Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 juin 1943, samedi 26 (no 26)
[" No.26 1151 Vol.75 Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, le samedi, 2G juin 1943\tQuebec, Saturday, June 26th, 1943 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1\" Adresser toute correspondance à: l'Impri- 1.Address ail communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3* Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising lies annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates 11 ant, exception est faite lorsque ces annonces doi- herein below set forth.Exception being made vent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit when the said advertising copy is to be published alors acquitter la facture sur réception et avant several times.The interested party shall then la deuxième insertion : sinon, cette dernière inser- pay upon reception of his account and before tion est suspendue, sans autre avis et sans préju- the second insertion: otherwise this last insertion dice aux droits de l'Imprimeur du Roi qui rem- will be suspended without further notice and bourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme ver- without prejudice as regards the rights of the see en surplus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for délai pour la réception des avis, documents ou receiving notices, documents or advertising annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi, copy, for publication, expires at noon on Thurs-à condition que l'un des trois derniers jours de la day, provided that none of the three last days of semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce der- the week be a holiday.In the latter case, the nier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, ultimate delay expires at noon on Wednesday. 1152 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 1943, No 26, Vol.75 Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.¦ Traduction : 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B\u2014Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième fait connaître la livraison de la Gazette pour la première insertion; le troisième indique le nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.2713\u20141-53 Lettres patentes \"B.Goodman Inc.\" Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier juin 1943, constituant en corporation : Ben Goodman, marchand, Dame Goldie Lazarus Goodman, ménagère, épouse séparée de biens dudit Ben Goodman et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de la cité de Montréal, Louie Numerof, voyageur de commerce, et Harry Mazer, agent d'immeubles, de la cité d'Outremont, tous du district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants : Exercer le commerce comme marchands et négociants à forfait de marchandises sèches et vêtements, comprenant vêtements pour hommes, dames et enfants ; exercer ce commerce en gros et en détail et comme exportateurs et importateurs ; et faire le commerce d'articles, commodités et tissus d'une utilité personnelle et domestique.Acheter, acquérir et prendre comme une entreprise en exploitation le commerce et l'entreprise ci-devant exercé en la cité de Montréal a 1117 Notices, documents or advertising copy not received on time, will l>e published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion : 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second designates the issue of the Gazette for the first insertion ; the third indicates the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.2713\u20141-53 Letters Patent \"B.Goodman Inc.\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with article 2, Chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of June, 1943, incorporating : Ben Goodman, merchant, Dame Goldie Lazarus Goodman, housewife, wife separate as to property of the said Ben Goodman and duly authorized by him for these presents, both of the City of Montreal, Louie Numerof, commercial traveller, and Harry Mazer, realtor, of the City of Outremont, all of the District of Montreal, Province of Quebec, for the following purposes : To carry on business as dealers and jobbers of dry goods and wearing apparel, including apparel for men, women and children ; to carry on such business wholesale and retail and as exporters and importers ; and to deal in articles, commodities and materials of |>ersonal and household use.To purchase, acquire and take over as a going concern the business and undertaking heretofore carried on in the City of Montreal at 1117 St. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 1943, No.26, Vol.75 1153 ouest, rue Ste-Catherine et ailleurs de B.Goodman avec tout l'actif et le passif d'icelui, sous le nom de \"B.Goodman Inc.\", avec un capital total de vingt mille dollars ($20,000), divisé en deux cents (200) actions de cent dollars ($100) chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district de Montréal.Daté du bureau du procureur général, ce premier juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3959 P.FRE NETTE.Catherine Street West and elsewhere of B.Goodman with all or any of the assets and liabilities thereof, under the name of \"B.Goodman Inc.\", with a total capital stock of twentv thousand dollars ($20,000.00), divided into two hundred (200) shares of one hundred dollars ($100.00) each.The head office of the company will l>e at Montreal, in the District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of June, 1943.P.FRENETTE, 3959-o Acting Deputy Attorney General.\"Canada Baskets Limitée\" \"Canada Baskets Limited\" Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date du quatrième jour de juin 1943, constituant en corporation : Joseph-Edouard Lachaine, gérant, Claire Grenier, épouse séparée de biens dudit Joseph-Edouard Lachaine, manufacturière, et Joseph-Hormidas Rivet, comptable, tous trois des cité et district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants : Opérer une manufacture et une fabrique de paniers de toutes sortes, boîtes, portes, chassis, jouets, ameublement de maison, bois préparés et de tous articles de construction en bois ou en métal, ou en tout autre matériel de construction et faire le commerce en général de tous articles susdits, sous le nom de \"Canada Baskets Limitée\" \u2014 \"Canada Baskets Limited\", avec un capital total de vingt mille dollars ($20,000.00), divisé en deux cents (200) actions de cent dollars ($100.00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera à Montréal, dans le district de Montréal.Daté du bureau du procureur général, ce quatrième jour de juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3960-o P.FRENETTE.\"Canada Baskets Limitée\" \"Canada Baskets Limited\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1943, incorporating: Joseph-Edouard Lachaine, manager, Claire Grenier, wife separate as to property of said Joseph-Edouard Lachaine, manufacturer, and Joseph-Hormidas Rivet, accountant, all three of the City and District of Montreal, Province of Quebec, for the following purposes : To operate a manufacture and a factory for all kinds of baskets, boxes, doors and sashes, toys, house furniture, dressed wood and all building requisites, of wood or metal, or of any other building material and to deal generally in all the aforementioned articles, under the name of \"Canada Baskets Limitée\"\u2014\"Canada Baskets Limited\", with a total capital stock of twenty thousand dollars ($20,000.), divided into two hundred (200) shares of one hundred ($100.) each.The head office of the company will be at Montreal, District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1943.P.FRENETTE, 3960 Acting Deputy Attorney General.\"La Société St-Jean Baptiste de Rouyn et de \"La Société St-Jean Baptiste de Rouyn et de Noranda Incorporée\" Noranda Incorporée\" Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québecxles lettres patentes, en date du cinquième jour de juin 1943, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph-H.Bertrand, agent d'assurances, et Léo Bureau, avocat, tous deux de Noranda, Joseph-H.Bellehumeur, contracteur, et Camille Beau-lieu, avocat, ces deux derniers de Rouyn, et tous de la province de Québec, dans les buts suivants : Succéder dans tous les biens, droits, pouvoirs, provilèges et obligations de la Société St-Jean Baptiste de Rouyn et Noranda, laquelle n'est pas incorporée ; Encourager et promouvoir l'union et la protection au point de vue national des canadiens catholiques de langue française et des étrangers catholiques de langue française, naturalisés canadiens ou considérés comme canadiens, sous le nom de \"La Société St-Jean Baptiste de Rouyn et de Noranda Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de vingt mille dollars ($20,000.00).Notice is given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1943, to incorporate as a corporation without share capital : Joseph H.Bertrand, insurance agent, and Léo Bureau, advocate, both or Noranda, Joseph H.Bellehumeur, contractor, and Camille Beaulieu, advocate, these two last mentioned of Rouyn, and all of the Province of Quebec, for the following purposes,: To assume all the assets, rights, powers, privileges and obligations of the \"Société St-Jean Baptiste de Rouyn et Noranda\" which has not been incorporated ; To encourage and promote the union and protection, from a national viewpoint, of Catholic Canadians of the French language and of foreign Catholics speaking the French language, naturalized Canadians or considered as Canadians, under the name of \"La Société St-Jean Baptiste de Rouyn et de Noranda Incorporée\".The amount to which the immovable property which the corporation may possess is to be limited, is twenty thousand dollars ($20,000). 1154 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 1943, No 26, Vol.75 Le bureau principal de la corporation sera à Rouyn, dans le comté de Témiscamingue, province de Québec.Daté du bureau du procureur général, ce cinquième jour de juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3961-o P.FRENETTE.\"L'Association de la Colonie de Vacances de Granby\" Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-septième jour de mai 1943, constituant en corporation sans capital-actions: Drs Joseph-V.Goyette et René-F.Bruneau, médecins, Raoul-A.Lafrenaye, gérant de banque, J.-Maurice Benoit, contrôleur, Georges Loiselle, hôtelier, Gérard Laliberté, technicien, Rhéaume-L.Deniers, industriel, Jean Goyette, avocat, et Charles Garceau, comptable, tous de Granby, province de Québec, dans les buts suivants: Fonder, établir, organiser et maintenir en existence une Colonie de Vacances pour les enfants; recevoir les enfants pauvres et en prendre soin; leur venir en aide tant au point de vue physique qu'au point de vue moral et intellectuel; se dévouer a toutes sortes d'œuvres sociales et philanthropiques se rapportant aux enfants; aménager et entretenir un camp d'été, sous le nom de \"L'Association de la Colonie de Vacances de Granby\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de dix mille dollars («10,000.00).Le bureau principal de la corporation sera au N° 87, rue Principale, à Granby, dans le district de Bedford.Daté du bureau du procureur général, ce vingt-septième jour de mai 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3962-o P.FRENETTE.\"Montreal Fruit Receivers Association Inc.\" Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier juin 1943, constituant en corporation: Arthur Crelinsten, Harry Letovsky, Alex Solomon, James Caldwell, Hector Campbell, Mendel Gerszenowicz et Philip Paskin, marchands de fruits, des cité et district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants: Unir en une organisation mutuelle et coopérative les marchands de fruits et de légumes en gros de la cité de Montréal dans le but de protéger leurs commerces et leurs intérêts commerciaux; établir des règlements et des pratiques de commerce uniformes; éliminer les maux et les abus du commerce et promouvoir par aucun moyen légal les intérêts des commerces qui sont exercés par les actionnaires; Agir comme gérants et agents de fret et de transport, ajusteurs pour et au nom de gardiens de quais, entreposeurs, expéditeurs et transporteurs par terre et par eau, sous le nom de \"Montreal Fruit Receivers Association Inc.\" Le capital-actions de la compagnie est divisé en cent actions n'ayant aucune valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec The head office of the corporation will be at Rouyn, in the County of Témiscamingue, Province of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1943.P.FRENETTE, 3961 Acting Deputy Attorney General.\"L'Association de la Colonie de Vacances de Granby\" Notice Ls hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1943, to incorporate as a corporation without share capital : Drs.Joseph-V.Goyette and René-F.Bruneau, physicians, Raoul-A.Lafrenaye, bank manager, J.-Maurice Benoit, comptroller, Georges Loiselle, hotel-keeper, Gérard Laliberté, technician, Rhéaume-L.Deniers, manufacturer, Jean Goyette, advocate, and Charles Garceau, accountant, all of Granby, Province of Quebec, for the following purposes : To found, establish, organize and keep up vacation camps for children ; to receive and take care of poor children ; to help them from a physical and a moral and intellectual viewpoint; to be devoted to all kinds of social and philanthropic works in connection with children ; to equip and maintain a summer camp under the name of \"L'Association de la Colonie de Vacances de Granby\".The amount to which the immovable property which the corporation may possess Ls to be limited is ten thousand dollars ($10,000.).The head office of the corporation will be at No.87, Principale street, Granby, District of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1943.P.FRENETTE, 3962 Acting Deputy Attorney General.\"Montreal Fruit Receivers Association Inc.\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with article 2, Chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of June, 1943, incorporating: Arthur Crelinsten, Harry Letovsky, Alex Solomon, James Caldwell, Hector Campbell, Mendel Gerszenowicz and Philip Paskin, fruit merchants, of the City and District of Montreal, Province of Quebec, ' for the following purposes : To unite into a mutual and co-operative organization wholesale fruit and vegetable merchants in the City of Montreal, for the purpose of protecting their trade ana commercial interests; to establish uniform trade practice and regulations; to eliminate trade evils and abuses and to advance in every lawful way the interests of the businesses in which the shareholders are engaged ; To act as freight and traffic managers and agents, adjusters, and for and on behalf of wharfingers, warehousemen, forwarders and carriers by land and water, under the name of \"Montreal Fruit Receivers Association Inc.\" The capital stock of the company is divided into one hundred shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 1943, A'o.26, Vol.75 115,5 lequel la compagnie commencera ses opérations sera de cinq cents dollars ($500) ; lies actions autres que les actions privilégiées seront émises et réparties pour telle considération que le conseil d'administration «le la compagnie pourra déterminer de temps a autre.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district «le Montréal.Daté du bureau du procureur général, ce premier juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3063 1».FRENETTE.\"Spearton Investments, Limited\" Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu «le*la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, représenté par M.Alfred M«)risset, conformément I l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, «les lettres patentes en date du premier juin 1943, constituant en corporation: Jacques Senécal, conseil en loi du Roi, Roger Beaulieu, avocat, Mary Griffiths, fille majeure, comptable, Sarah Grace Little, fille majeire, sténographe, et Elizabeth Beveridge.fille majeure, sténographe, tous des cité et district de Montréal, province de Québec,'dans les buts suivants : Souscrire conditionnellement ou non, souscrire éventuellement à forfait, acquérir, acheter, prendre, détenir, faire le commerce, vendre a commission ou autrement, convertir ou en aucune manière disposer d'actions, parts, hypothèques, obligations, délxmtures, aetions-dél>entures et placements et valeurs de toutes sortes, sous le nom de \"Spearton Investments, Limited\", avec un capital total de vingt mille dollars ($20,000), divisé en deux cents (200) actions de cent dollars ($100) chacune.Le siège social de la compagnie sera en la «-ité «le Montréal, district de Montréal.Daté du bureau «lu procureur général, ce premier juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3964 P.FRENETTE.Lettres patentes supplémentaires which the comiiany will commence its operations will be five hundred dollars ($500.00); Shares other than preferred shares shall be issued and allotted for such «-onsideration as the Boanl of Directors of the Company may from time to time determine.The head office of the company will be at Montreal, in the District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of June, 1943.P.FRENETTE, 3963 «) Acting Deputy Attorney General.\"Spearton Investments, Limited\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Pr«)vince of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with article 2, Chapter 876, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of June, 1943, incorporating: Jacques Senécal, King's Counsel, Roger Beaulieu, advocate, Mary Griffiths, spinster, accountant, Sarah Grace Little, spinster, stenographer, and Elizabeth Beveridge, spinster, stenographer, all of the City and District of Montreal, Province of Quebec, for\" the following purposes : To subscribe for, conditionally or unconditionally, underwrite, acquire, purchase, take, hold, deal in, sell on commission or otherwise, convert or in any manner dispose of, stocks, shares, mortgages, bonds, debentures, delwnture stock ami investments and securities of all kinds, under the name of \"Spearton Investments, limited\", with a total capital stock of twenty thousand dollars ($20,000.00), divided into two hundred (200) shares of one hundred dollars ($100.00) each.The head office of the company will be at the City of Montreal, in the District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of June, 1943.P.FRENETTE, 3964-o Acting Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent \"Capital Economy Corporation\" Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du sept juin 1943, à la compagnie \"Capital Economy Corporation, ratifiant son règlement N° 24, diminuant son capital de $99,000 à $9,000 par l'annulation de 900 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du procureur général, ce sept juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3965 P.FRENETTE.\"New Calumet Mines Limited\" (Libre de responsabilité personnelle) Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du cinq juin 1943, à la compagnie \"New Calumet Mines \"Capital Economy Corporation\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the seventh day of June, 1943, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Capital Economy Corporation\", ratifying its By-law No.24, reducing its capital from $99,000.00 to $9,000.00, by the cancellation of 900 shares of the par value of $100.00 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of June, 1943.P.FRENETTE, 3965-0 Acting Deputy Attorney General.\"New Calumet Mines Limited\" (No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the fifth day of June, 1943, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"New Calumet Mines Limited\" (No Per- 1156 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 190, No 26, Vol.75 Limited\" (Librede responsabilité j>ersonnelle), ratifiant son règlement spécial \"H\", augmentant son capital de 18,000,000 à 13,600,000 par la création de 800(000 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de «1 chacune.Daté du bureau du procureur général, ce cinq juin 1943.L'Assistant-procureur général suppléant, 3966 P.FRENETTE.Ventes pour taxes municipales Canada, Province de Québec, District de Bedford.La Corporation de la Municipalité de la Cité de Granby.Avis public est par les présentes donné par Arthur Montfils, secrétaire-trésorier de la cité de Granby, que les propriétés ci-après désignées seront vendues :\\ l'enchère publique, au bureau du Conseil, à l'Hôtel-de-Ville de Granby, le JEUDI 15 JUILLET 1943, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et d'eau, avec intérêts, ainsi que des /rais subséquents encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépeni ne soient payés avant la vente.1.Re: J.-A.Côté, Propriétaire ou Occupant.A) Un lopin de terre situé au coin nord-ouest de la rue Cowie et de la rue St-Antoine Sud dans la cité de Granby, mesurant (50 pieds de largeur le long de ladite rue Cowie, par 66 pieds en profondeur le long de ladite rue St-Antoine Sud, plus ou moins, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour le cadastre du ci-devant village de Granby comme étant partie sud-est du lot N° 316, avec les bâtisses dessus construites et comprenant les numéros civiques 299, 301 et 305 de la rue Cowie.Taxes municipales foncières.$215.25 Intérêts sur taxes foncières.18.45 Taxe d'eau.97.50 Intérêt sur taxe d'eau.10.75 Frais.Total: S B) Un lopin de terre situé sur le côté ouest de la rue St-Antoine Sud, dans la cité de XJranby, mesurant 70 pieds de largeur par 60 pieds de profondeur plus ou moins, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour le cadastre du ci-devant village de Granby, comme étant partie sud-est du lot N° 316, avec les bâtisses dessus construites et étant les numéros civiques 132, 134, 136 et 138 de ladite rue St-Antoine Sud.Taxes municipales foncières.$ 180.60 Intérêts sur taxes municipales foncières.15.39 Taxes d'eau.114.20 Intérêts sur taxe d'eau.10.34 Frais.Total: $ C) Un certain morceau de terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du Canton de Granby, faisant maintenant partie de la Cité de Granby, comme étant les lots Nos 125 et 126 de la subdivision officielle du lot originaire N° 628, mesurant 60 chacun en largeur par toute la profondeur desdits lots.sonal Liability), ratifying its Special By-law \"B\", increasing its capital from $3,000,000.to $3,500,-000., by the creation of 600,000 additional common shares of the par value of $1.00 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1943.P.FRENETTE, 8060 (\u2022 Acting Deputy Attorney General.Sales for Municipal Taxes Canada, Province of Quebec, District of Bedford.Corporation of the Municipality of the City of Granby.Public notice is hereby given by Arthur Montfils, secretary-treasurer of the City of Granby, that the pro|>erties hereinafter designated will be sold bv public auction, at the Council Bureau, at the City Hall of Granby, on THURSDAY, the FIFTEENTH day of JULY, 1943, at TEN o'clock in the forenoon, for the non-payment of municipal and water taxes, with interest, and also of subsequent costs incurred, unless said taxes, interest and costs be paid before the sale.1.Re: J.A.Côté, Owner or occupant.A) A parcel of land situate at the northwest corner of Cowie and St.Antoine South streets, in the city of Granby, measuring 60 feet in width along said Cowie street by 66 feet in depth along said St.Antoine street South, more or less, known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the heretofore Village of Granby as being the southeast part of lot No.316, with the buildings thereon erected and including civic numbers 299, 301 and 305 of Cowie Street.Municipal ground taxes.$ 215.25 Interest on ground taxes.18.45 \u2022 Water tax.97.50 Interest on water tax.10.75 Costs.Total: $ B) A parcel of land situate on the west side of St.Antoine street South, in the city of Granby, measuring 70 feet in width by 60 feet in depth, more or less, known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the heretofore village of Granby as being the southeast part of lot No.316, with the buildings thereon erected and being civic numbers 132, 134, 136 and 138 of said St.Antoine street South.Municipal ground taxes.$ 180.60 Interest on Municipal ground taxes.15.39 Water tax.114.20 Interest on water tax.10.34 Costs.Total: $ C) A certain parcel of land known and designated on the official plan and in the book of reference for the township of Granby, now forming part of the city of Granby, as being lots Nos.125 and 126 of the official subdivision of original lot No.628, each measuring 60 in width by the whole depth of the said lots. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 1943, No.26, Vol.75 1157 Taxes municipales foncières.$ 18.20 Intérêts sur taxes municipales foncières.1.50 Frais.Total: $ 2.Re: Paul Paradis, Propriétaire ou Occupant.Un lopin de terre situé dans la cité de Granby, du côté ouest de la rue ('artier, autrefois rue Boivin, connu et désigné comme étant le lot N° 164 de la subdivision officielle du lot originaire N° 444 aux plan et livre de renvoi officiels du ci-devant village de Granby, mesurant 150 pieds de largeur par 130 pieds plus ou moins.Taxes municipales foncières.S 8.40 Intérêts.0.63 Frais.Total : S 3.Re: G.W.Hill, Propriétaire ou Occupant.Un lopin de terre formant partie du lot N° 126 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour le ci-devant village de Granby, mesurant 30 pieds de largeur à, travers les extrémités est et ouest dudit lot par 186 pieds en profondeur et borné comme suit : au sud par la ligne nord des lots faisant face à la rue Drummond, à l'est par une ligne tirée du nord au sud à une distance de 146 ouest du chemin conduisant à Shefford Nord et au nord et à l'ouest par le résidu dudit lot 126 réservant cependant de ce que susdit un morceau de terre de 40 pieds de large à travers la limite ouest dudit terrain pour la continuation de l'avenue Aberdeen.Taxes municipales foncières.$ 8.40 Intérêts.0.63 Frais.Total : S Donné sous mon seing à Granby, ce quatorzième jour de juin mil neuf cent quarante-trois.Le secrétaire-trésorier pour la Corporation de la Municipalité de la Cité de Granby, 3937-25-2-0 ARTHUR MONTFILS.AVIS Que le DOUZIÈME jour de JUILLET 1943, à DIX heures de l'avant-midi, à l'Hôtel de Ville, de la Cité des Trois-Rivières, les terres et héritages ci-dessous désignés, situés dans la Cité des Trois-Rivières, seront vendus comme étant grevés de taxes municipales et scolaires et d'arrérages de taxes consolidées, qui n'ont pas été payées dans les six mois après l'avis du dépôt du rôle, tel que requis par la loi, savoir: 1.Un emplacement situé du côté nord-est de la rue St-Paul, connu et désigné comme étant le lot N° 1831-41 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné en front, vers le sud-ouest, par la rue St-Paul; en profondeur, vers le nord-est, par le lot N° 1929-13; d'un côté, vers le nord-ouest, par le lot N° 1831-40; et de l'autre côté, vers le sud-est, par le lot N° 1831-41a, comme appartenant à M.Ernest Dumoulin & al.2.Un emplacement situé du côté sud-ouest de la rue St-Paul, connu et désigné comme étant le lot N° 1821-6 d'une subdivision non officielle du lot N° 1821 et d'une partie du lot N° 1755-P-379, du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné en front, vers le nord-est par la rue Municipal ground taxes.$ 18.20 Interest on Municipal ground taxes.1.56 Costs.Total: * 2.Re : Paul Paradis, Owner or occupant.A parcel of land situate in the city of Granby, on the west side of Cartier street, heretofore Boivin street, known and designated as being lot No.164 of the official subdivision of original lot No.444 on the official plan and in the book of reference of the heretofore village of Granby, measuring 150 feet in-width by 130 feet more or less.Municipal ground taxes.$ 8.40 Interest.0.63 Costs.Total: $ 3.Re: G.W.Hill, Owner or occupant.A parcel of land forming part of lot No.126 on the official cadastral plan and in the book of reference for the heretofore Village of Granby, measuring 30 feet in width across the Eastern and Western extremities of said lot by 186 feet in depth and bounded as follows: On the South by the Northern line of the lots facing Drummond street, on the East by a line drawn form North to South at a distance of 146 West of the road leading to North Shejfford and on the North and West by the residue of said lot 126 reserving, however, from the aforesaid a strip of land 40 feet wide across the Western limit of said lot for the continuation of Aberdeen Avenue.Municipal ground taxes.$ 8.40 Interest.0.63 Costs.Total: S Given under my seal at Granby, this fourteenth day of June, one thousand nine hundred and forty- ARTHUR MONTFILS, Secretary-Treasurer for the Municipal 3937-25-2 Corporation of the City of Granby.NOTICE That on the TWELFTH day of JULY 1943, at TEN o'clock in the forenoon, at the City Hall, of the City of Trois-Rivières, the lands and hereditaments hereinbelow designated, situate in the City of Trois-Rivières, will be sold as being encumbered by Municipal and School taxes and arrears of consolidated taxes, which have not been paid within six months after the notice of the fyling of the roll, as required by law, to wit: 1.An emplacement situate on the Northeast side of St.Paul street, known and designated as being lot No.1831-41 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front, on the Southwest by St.Paul street ; on the depth, on the Northeast, by lot No.1929-13; on one side, on the Northwest, by lot No.1831-40; and on the other side, on the Southeast by lot No.1831-41a, as belonging to M.Ernest Dumoulin et al.2.An emplacement situate on the Southwest side of St.Paul street, known and designated as being lot No.1821-6 of a non-official subdi-divison of lot No.1821 and of part of lot No.1755-P-379 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front on the Northeast 1158 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 86 juin 190, No 26, Vol.75 .St-Paul;en profondeur, vers le sud-ouest, par les lots Nos 1755-323, 322 et 321; d'un côté, vers le sud-est, par les lots Nos 1821-9 et 1755-379-9; et de l'autre côté, au nord-ouest par le lot N° 1821-7 d'une subdivision non officielle du lot N\" 1821 et une partie du lot N° 1755-P-379, comme appartenant à M.Ernest Dumoulin & al.3.Un emplacement situé du côté sud-ouest de la rue St-Paul, connu et désigné comme étant le lot N° 1821-7 d'une subdivision non officielle du lot N° 1821 et une partie du lot N° 1755-P-379 du Cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné en front, vers le nord-est, par la rue St-Paul ; en profondeur, vers le sud-ouest, par les lots Nos 321, 320 et 319; d'un côté Vers le sud-est, par le lot N° 1821-0 d'une subdivision non officielle du lot N° 1821 et une partie du lot N° 1755-P-379; et de l'autre côté au nord-ouest par la balance du lot N° P-1821 et 1755-P-379, comme appartenant à M.Ernest Dumoulin & al.4.Un emplacement situé du côté nord-est de la rue Ste-Cécile, connu et désigné comme étant le lot N° 1831-P-27, P-28, P-33 et P- 34 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné en front, vers le sud-ouest par la rue Ste-Cécile; en profondeur vers le nord-est, par les lots Nos 1831-30 et 32; d'un côté vers le sud-est par la partie des lots Nos 1831-P-27 et P-28; et de l'autre côté au nord-ouest, par la rue Charlevoix, comme appartenant à Ernest Dumoulin & al.5.Un emplacement situé du côté sud-ouest de la rue Dénoue, connu et désigné comme étant le le lot N° 1404 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné en front, vers le nord-est par la rue Dénoue; en profondeur, vers le sud-ouest par le lot N° 1393; d'un côté vers le sud-est par le lot N° 1405 et de l'autre côté, vers le nord-ouest, par le lot N° 1403, comme appartenant à Ernest Dumoulin & al.6.Un emplacement situé du côté nord-ouest de la rue St-Philippe, connu et désigné comme étant le lot N° P-444 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné en front, au sud-est, par la rue St-Philippe; en profondeur, au nord-ouest, par une partie du lot N° 20; d'un côté, au nord-est, par le Boulevard Normand, et de l'autre côté, au sud-ouest, par une partie du lot N° 11 comme appartenant à Ernest Dumoulin ci al.7.Un emplacement situé du côté sud-ouest de la rue St-Georges connu et désigné comme étant le lot N° P-389 du Cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, portant le N° 371 de la rue St-Georges, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, borné en front, au nord-est par la rue St-Georges; en profondeur, au sud-ouest par le lot N° 332; d'un côté vers le sud-est, par l'autre partie du dit lot N° P-389; et de l'autre côté, vers le nord-ouest, par lelotN\" 388, comme appartenant à MM.Donat & Armand Gauthier.8.Un emplacement situé du côté sud-ouest de la rue St-Georges, connu et désigné comme étant le lot N° P-388 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant les numéros civiques 413-419 rue St-Georges et 1021 rue Royale, borné au front, au nord-est, par la rue St-Georges, en profondeur, au sud-ouest, par une partie du dit lot N° P-388; d'un côté vers le sud-est, par une partie du lot N° P-389 et de l'autre côté, au nord-ouest, par la rue Royale, comme appartenant à MM.Donat «t Armand Gauthier.by St.Paul street ; on the depth, on the Southwest by lots Nos.1755-323, 322 and 321 ; on one side, on the Southeast, by lots Nos.1821-9 ami 1755-379-9; and on the other side, on the Northwest by lot No.1821-7 of a non-official subdivision of lot No.1821 and a part of lot No.175Ô-P-379, as belonging to M.Ernest Dumoulin et al.3.An emplacement situate on the Southwest side of St.Paul street, known and designated as being lot No.1821-7 of a non-official subdivision of lot No.1821 and part of lot No.1755-P-379 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front, on the Northeast by St.Paul street; on the depth, on the Southwest by lots Nos.321, 320 and 319; on one side, on the Southeast by lot No.1821-0 of a non-official subdivision of lot No.1821 and uart of lot No.1755-P-379; and on the other side on the Northwest by the residue of lot No.P-1821 and 1755-P-379, as belonging to M.Ernest Dumoulin et al.4.An emplacement situate on the Northeast side of Ste-Cécile street, known and designated as being lot No.1831-P-27, P-28, P-33, and P-34 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front, on the Southwest by Ste-Cécile street; on the depth, on the Northeast, by lots Nos.1831-30 and 32; on one side, on the Southeast by the part of lots Nos.1831-P-27 and P-28; and on the other side, on the Northwest, by Charlevoix street, as belonging to Ernest Dumoulin et al.5.An emplacement situate on the Southwest side of Denoue street, known and designated as being lot No.1404 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front, on the Northeast by Denoue street ; on the depth, on the Southwest, by lot No.1393; on one side, on the Southeast, by lot No.1405 and on the other side, on the Northwest, by lot No.1403, as belonging to Ernest Dumoulin et al.0.An emplacement situate on the Northwest side of St.Philippe street, known and designated as being lot No.P-444 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front, on the Southeast by St.Philippe street ; on the depth, on the Northwest, by part of lot No.20; on one side, on the Northeast, by Normand Boulevard, and on the other side, on the Southwest, by part of lot No.11, as belonging to Ernest Dumoulin et al.1.An emplacement situate on the Southwest side of St-Georges street, known and designated as being lot No.P-389 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bearing No.371 of St.Georges street\u2014with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, bounded in front on the Northeast by St.Georges street; on the depth, on the Southwest, by lot No.332; on one side on the Southeast by the other part of said lot P-389; and on the other side, on the Northwest, by lot No.388, as belonging to Messrs.Donat & Armand Gauthier.8.An emplacement situate on the Southwest side of St-Georges street, known and designated as being lot No.P-388 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières\u2014with buildings thereon erected, circumstances and dependencies \u2014bearing civic numbers 413-419 of St-Georges street and 1021 of Royale street, bounded in front on the Northeast, by St.Georges street; on the depth, on the Southwest, by part of said lot P-388; on one side, on the Southeast by part of lot No.P-389 and on the other side, on the Northwest, by Royale street, as belonging to Messrs.Donat & Armand Gauthier. \\ 9.Un emplacement situé du côté sud-ouest de la rue Laviolette, connu et désigné comme étant une partje du lot 2105 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, avec maisons dessus construites, et j>ortant les numéros civiques 151 et 153 de la rue Laviolette, home en front du côté nord-est par la rue Laviolette, d'un côté, au nord-ouest par le résidu du lot N° 2105, et à l'arrière au sud-ouest par le lot N° 2103 et de l'autre côté au sud-est par le lot N° 2100, comme appartenant à la Succession Uhald Bureau.10.Un emplacement situé du côté sud-ouest de l'Avenue I^aviolette, connu et désigné comme étant le lot N° P-2105 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, avec bâtisses dessus construites, circonstances et déjiendances, portant les numéros civiques 107-109 Avenue Laviolette, borné en front, au nord-est par l'Avenue Laviolette, en profondeur, au sud-ouest, par le lot N° 2103; d'un côté au sud-est par l'autre partie du dit lot N° P-2105; et de l'autre côté, au nord-ouest, par le lot N° 2104, comme appartenant à Madame Veuve Lydéric Bouille.11.Un emplacement situé du côté nord-ouest de la rue Royale, connu et désigné comme étant le lot N° 387 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, borné eiu front au sud-est, par la rue Royale; en profondeur au nord-ouest, par le lot N° 384; d'un côté, vers le nord-est, par les lots Nos 385 et 380; et de l'autre côté, vers le sud-ouest, par les lots Nos 333 et 334, comme appartenant à MM.Donat & Armand Gauthier.12.Un emplacement situé du côté sud-est de la rue Royale, connu et désigné comme étant le lot N° P-388 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, jx>rtant les nos civiques 1045-1047 Royale, borné en front, au nord-ouest, par la rue Royale; en profondeur, au sud-est, par une partie du lot N° P-389; d'un côté, vers le sud-ouest, par le lot N° 332; et de l'autre côté, vers le nord-est, par l'autre partie du dit lot N° P-388, comme appartenant à M.J.Donat Gauthier (Fils Félix).13.Un emplacement de forme irrégulière faisant face au côté tJuest de la rue Bellefeuille, dans la cité des Trois-Rivières, province de Québec, connu et désigné comme étant une partie du lot N° 20, aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Cité des Trois-Rivières, étant borné comme suit: En front du côté sud-est, par la rue Bellefeuille; en arrière du côté nord-ouest par l'emprise d'une partie du dit lot N° 20, vendue à Girard & Godin Ltée par la Cité des Trois-Rivières, selon un acte de vente exécuté par le notaire P.0.Guillet, le lOième jour du mois de juillet 1905, enregistré au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement des Trois-Rivières, sous le N° 48,553; du côté nord-est par une autre partie du dit lot NTo 20, connue sous le nom de \"La Commune\" appartenant à la Cité des Trois-Rivières et de l'autre côté au sud-ouest par d'autres parties du dit lot N° 20 appartenant à Georges Christie Ltd et à la dite Cité des Trois-Rivières et comprenant une superficie d'environ 344,800.77 pieds\u2014trois cent quarante-quatre mille huit cents pieds et .77 pied en mesure anglaise et plus ou moins, le surplus ou le manque de superficie devant être au bénéfice ou à la perte de l'acquéreur; la ligne nord-est du dit emplacement étant le prolongement en ligne droite de la ligne 9.An emplacement situate on the Southwest side of Laviolette street, known and designated as l>eing part of lot 2105 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières\u2014with houses thereon erected\u2014and bearing civic numbers 151 and 153 of Laviolette street, bounded in front, on the Northeast by Laviolette street, on one side, on the Northwest by the residue of lot No.2105 and in rear on the Southwest, by lot No.2103, and on the other side, on the Southeast, by lot No.2100, as t>elonging to the Estate of Ubald Bureau.10.An emplacement situate on the Southwest side of Laviolette avenue, known and designated as being lot No.P-2105 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières\u2014with buildings thereon erected, circumstances and dependencies \u2014bearing civic numbers 107-109 Laviolette avenue, bounded in front on the Northeast by Laviolette avenue, on the depth, on the Southwest by lot No.2103; on one side on the Southeast by the other part of said lot No.P-2105; and on the other side, on the Northwest, by lot No.2104, as belonging to Madame Widow Lydéric Bouille.11.An emplacement situate on the Northwest side of Royale street, known and designated as being lot No.387 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières, bounded in front, on the Southeast by Royale street ; on the depth on the Northwest, by lot No.384; on one side, on the Northeast, by lots Nos.385 and 380; and on the other side, on the Southwest by lots Nos.333 and 334, as belonging to Messrs.Donat & Armand Gauthier.12.An emplacement situate on the Southeast side of Royale street, known and designated as being lot No.P-388 of the official cadastre for the City of Trois-Rivières\u2014with buildings thereon erected, circumstances and dependencies \u2014bearing civic numbers 1045-1047 Royale, bounded in front, on the Northwest, by Royale street; on the depth, on the Southeast by part of lot No.P-389; on one side, on the Southwest, by Jot No.332; and on the other side, on the Northeast by the other part of said lot No.P-388, as belonging to M.J.Donat Gauthier (son of Félix).13.An emplacement of irregular figure facing on the West side of Bellefeuille street, in the City of Trois-Rivières, Province of Quebec, known and designated as being a part of lot No.20, on the official cadastral plan and in the book of reference of the City of Trois-Rivières, being bounded as follows: In front on the Southeast side, by Beiiefeuille street; in rear on the Northwest side by the right of way of a part of said lot No.20, sold to Girard & Godin Ltée by the City of Trois-Rivières, according to deed of sale passed by Notary P.O.Guillet, on the 10th day of the month of July, 1905, registered at the Registry Office of the Registration Division of Trois-Rivières, under No.48,553; on the Northeast side by another part of said lot No.20, known under the name of \"La Commune\" belonging to the City of Trois-Rivières and on the other aide on the Southwest by other parts of said lot No.20 belonging to Georges Christie Ltd and to the said City of Trois-Rivières and comprising an area of about 344, 800.77 feet\u2014three hundred and forty-four thousand eight hundred feet and .77 of a foot English measure and more or less, the more or the less of the superficies to the profit or loss of the purchaser; the Northeast line of the said emplacement being the prolongation in a QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 1943, No.26, Vol.76 1160 1160 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, (Québec, 26 juin 190, No 26^ Vol.76 sud-ouest de lu rue La Vérendrye, le dit emplacement étant particulièrement décrit comme suit: commençant à un point sur le côté nord-ouest de la rue Bellefeuille, situé au |>oint de rencontre du dit prolongement de la ligne sud-ouest de la dite rue La Vérendrye, «le la procédant en direction nord-ouest une distance de neuf cents pieds et soixante-deux centièmes ((KM) pi (i'2') à un point distant de vingt-ciiuj pieds du droit de passage de la Canadian Pacific Railway, de là tournant à un angle de 122 degrés et 21 minutes et allant en direction sud-ouest sur une distance de quatre cent cinquante et un pieds et 10 centièmes (451 pi 10') le long de la ligne de séparation entre ledit emplacement et la propriété de Girard & Godin Ltée, le long dudit droit de passage de la dite Canadian Pacific Railway Company; de là tournant à un angle de 56 degrés et 4 minutes et avançant en direction sud-est sur une distance de 563 pieds et 4 centièmes (563.04) à un point où cette ligne touche la ligne arrière de la propriété de Georges Christie Ltd; de là tournant à angle droit et allant en direction nord-est le long delà ligne arrière de la dite propriété de Georges Christie, une distance de 50 pieds; de là tournant à angles droits et allant en direction sud-est en direction de la ligne de séparation entre ledit emplacement et la dite propriété de Georges Christie Ltd, une distance de 600 pieds d'un point situé sur le côté nord-ouest de ladite rue Bellefeuille; de là tournant à un angle de 88 degrés et 29 minutes en allant en direction nord-est le long du côté nord-ouest de la dite rue Bellefeuille, une distance de trois cents pieds (300 pieds) du point de départ.6) Tous les droits, titres et intérêts du vendeur dans cette autre bande de terre formant partie dudit lot N° 26, dudit cadastre, formant un rectangle uniforme de 25 pieds de largeur et mesurant trente pieds (30) dans sa ligne nord-est et 48 pieds .4 dans sa ligne sud-ouest.Dans sa ligne nord 374 pieds et .7 pied et dans sa ligne sud 350.6 pieds, borné comme suit: au nord par la partie dudit lot N° 26 appartenant à Dominion Manufacturing Co.Limitée!, au sud par une autre partie dudit lot N° 26, appartenant à la Cité des Trois-Rivières ou ses représentants, au nord-est par la propriété ci-dessus premièrement décrite et au sud-ouest par la ligne de chemin de fer doublement alternante de la Canadian Pacific Railway.(memo) Cette propriété décrite en second lieu est sujette à la clause citée ci-après, contenue dans l'acte de vente de la Cité des Trois-Rivières à Archibald H.Chave, exécuté devant J.A.D.Chagnon, Notaire, le 13ième jour de septembre 1929 sous le N° 3122 du répertoire du dit J.A.D.Chagnon, dont la clause se lit comme suit: \"Que si le dit mandataire cessait de faire usage de la dite bande de terre pour le besoin susdit, la dite bande de terre devra retourner au commettant et le mandataire s'engagera à signer un acte à cet effet en faveur dudit commettant\".La propriété immobilière décrite ci-dessus apparaît sur un plan préparé par J.T.Z.Patenaude, arpenteur des terres pour la province de Québec, portant la date du 21 juin 1929, un plan est annexé à l'acte de venté de la Quebec Gas & Electric Corporation à la City Gas & Electric Corporation Ltd, exécuté devant Donald M.Rowat, notaire, le 21ième jour du mois de juillet 1931, sous le numéro 13634 de ses minutes, les propriétés affectées premièrement et secondement étant comprises respectivement sur le plan en lignes rouges et jaunes, avec tous ses droits, parties et dépendances comprenant tous les droits de propriété et les autres droits acquis straight line of the Southwest line of La Vérendrye street, the said emplacement being more amply described as follows: starting at a point on the Northwest side of Bellefeuille street, situate at the junction of the said prolongation of the Southwest line of said La Vérendrye street, thence bearing Northwest a distance of nine hundred feet and sixty-two hundredths (900 ft.62') to a point twenty-five feet «listant from the right of way of the Canadian l*acifie Railway, thence, turning at an angle of 122 degrees and 21 minutes and bearing Southwest a distance of four hundred and fifty-one feet and 10 hunert.Paltiel, Dame-Mrs.Bella It.(épouse de-wife of Pal tiel, A.D.).Poirier, Joseph T.Prefontainc, Joseph N.,1 it Ross, Dr.Herbert.Salvation Army.Stalker, Wm.N° du cadastre Cadastral Number\tl'axes\t\tIntérêt et frais Interest & Gosts\t\tTotal\t 139-608.a .139-370pt.& 371?.\tS 172\t44\tS 13\t38\t8 185\t82 \t297\t(M\t21\t18\t318\tin 140-320 .\t170\t89\t12\t78\t192\t17 138-E-20.\t159\t83\t11\tr>:i\t171\t:u> 138-398 à-to 403.\t76\t06\t5\t38\t81\t44 138-455 à-to 458____\t50\t71\t3\t(il)\t54\t31 139-455.\t188\t42\t9\t90\t148\t82 139-499.\tTA\t98\t5\t2!)\t79\t27 138-144.\t176\t99\t12\t64\t188\t93 140-118 & 119\t425\t14\t30\t20\t455\t43 138-737 «t 738.\t25\t88\t1\t92\t27\t80 138-140 ec, 1941, chapitre 103), les parties contractantes a la convention collective de travail relative aux fonctionnaires municipaux de la cité de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 2074, du 12 juillet 1940, et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret: Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, livraison du premier mai 1943; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail, que ledit décret numéro 2074 soit modifié de la façon suivante :\u2014 1.\u2014L'article III suivant est ajouté: \"III.\u2014Aux fins d'application du présent décret les mots suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: a) Nomination:\u2014C'est le fait de choisir un titulaire pour remplir une fonction.b) Promotion:\u2014C'est la nomination d'un titulaire d'une fonction quelconque à une autre d'un grade plus élevé.c) Classification:\u2014C'est le fait de déterminer la dénomination ou le grade d'une fonction ou de les rectifier, en raison du travail effectué par le titulaire.Quand une fonction est vacante, il n'y a pas lieu à classification comme moyen de remplir la vacance.\" 2.\u2014L'article IV est remplacé par le suivant:\u2014 \"IV.\u2014Dès que le Comité Administratif a résolu qu'une nomination ou promotion est a faire, il charge le Comité de Conq>étence de faire subir un examen aux employés de la Cité d'abord et, si aucun d'eux ne se présente ou n'est trouvé apte, aux autres aspirants.Les diplômes et certificats de compétence déjà reconnus dispensent les aspirants ou candidats de l'examen devant le Comité de Compétence.Après quoi, sur recommandation du Comité de Compétence, le Comité Administratif et le Conseil de Ville choisissent le titulaire en tenant compte, autant que possible, des années de services.Lorsqu'il y a une classification à faire, le Comité de Compétence en est chargé et doit faire rapport au Comité Administratif.\" 3.\u2014L'article V suivant est ajouté: \"V.\u2014Le Comité de Compétence est composé de Son Honneur le Recorder ou du Recorder suppléant, comme président, du gérant général de la Caisse d'Économie, M.J.-À.Towner, ou de son représentant, du Directeur des services municipaux ou de son représentant, et du Président du Syndicat ou de son représentant.Le Comité doit s'adjoindre le chef du département où il s'agit de faire une nomination, promotion ou classification.\" 4.\u2014Le mot \"demie\", mentionné à l'article XI, est remplacé par les mots \"trois quarts\".5.\u2014L'article XV est remplacé par le suivant: \"XV.\u2014Les employés temporaires deviennent employés réguliers aux conditions suivantes: a.\u2014La fonction qu'ils occupent depuis au moins quatre (4) mois doit avoir été déclarée Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 103), the contracting parties to the collective labour agreement relating to municipal employees of the City of Qucl>ec, rendered obligatory by the decree number 2074, of July 12,1940, and amendments, have presented to the Minister of Dibour a request to modify the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette on May 1st, 1943; Whereas no objection against its approval has been set forth ; It Is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Lal>our, that the said decree number 2074 be modified in the following manner:\u2014 1.\u2014The following section III is added: \"III.\u2014For the purposes of enforcement of the present decree, the following words have the significance hereinafter given to them: a) Appointment:\u2014the act of choosing someone for an occupation.b) Promotion:\u2014the appointment of an employee to a higher occupation.c) Classification:\u2014the act of determining the importance or grade of an occupation or to adjust same with regard to the work done by the employee concerned.\" Should an occupation be vacant, the classification system shall not be used to fill the vacancy.2.\u2014Section IV is replaced by the following: \"IV.\u2014When the Administrative Committee has decided that an appointment or a promotion is to take place, it shall instruct the Competence Committee to have examinations undergone first among the employees of the City and, should none of them apply or be found qualified, by the other applicants.Diplomas or certificates of competency deemed valid shall exempt the applicants or candidates from the examination before the Competence Committee.Thereafter, upon recommendation of the Competence Committee, the Administrative Committee and the City Council shall choose with due consideration of the years of service.Classifications to be made shall be entrusted to the Competence Committee which shall report to the Administrative Committee.\" 3.\u2014The following section V is added : \"V.\u2014The Competence Committee shall consist of His Honor the Recorder or the Acting Recorder as chairman, of the general manager of \"La Caisse d'Économie\" Mr.J.-A.Towner, or his delegate, of the director of the municipal services or his delegate, of the chairman of the Syndicate or his delegate.The Committee shall also include the chief of the department when an appointment, a promotion or a classification is to l>e made.\" 4.\u2014The words \"one half\" mentioned in section XI are replaced by the words \"three-quarters\".5.\u2014Section XV is replaced by the following: \"XV.\u2014Temporary employees shall become regular employees as follows: a.\u2014The office which they have occupied for at least four (4) months must have been QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 190, No.26, Vol.76 1165 nécessaire pour l'avenir, par le Comité Adminis- declared necessary, for the future, by the Admin-tratif, sur rapport du Directeur des services.istrative Committee upon report of the director of services; 6.\u2014Ils doivent avoir subi avec succès un exa- 6.\u2014They shall have undergone, successfully, men devant le Comité de Compétence auquel exa- an examination before the Competence Commit-inen peuvent également prendre part les employés tee also operating for the permanent and regular j>ermanents et réguliers de la Cité.employees of the City; c\u2014Ils doivent être nommés à cette fonction enteur géomètre.\u2014 Engineers for public works services, deputy-clerk of the City, lawyer of the City, engineer director, Miiveyor.8,800 () 4,006.00 38.\u2014Premier assistant-trésorier.- First ass't-treasurer.4,000.00 4,.r)00.00\" WM.LBARMONTH.WM.LEARMontii, Asst.(îreffier du Conseil Exécutif.3988-o Dep.-Clerk of the Executive Council.3988e Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une nouvelle prolongation de la durée du décret relatif aux employés de pompée funèbres dans l'Ile de Montréal, l'Ile Jésus et un rayon de dix-(10) milles autour de l'Ile de Montréal.11 eel ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail, que le décret numéro 359, du 13 février 1942, relatif aux employés de pompes funèbres dans l'Ile de Montréal, l'Ile Jésus et un rayon de (10) milles autour de l'Ile de Montréal, soit de nouveau prolongé jusqu'au 10 juillet 1943.A.MORISSET, 9905-0 (îreffier du Conseil Exécutif.Number 1 ( > ~>een approved by Older in Council number 1042 of June 23, 1943.minimum wage commission By-law B 1 Revised enacting a Levy By-law of Amendment The Minimum Wage Commission, pursuant to the Minimum Wage Act (R.S.Q., 1941, c.104), Orders and decrees by the present By-law of Amendment, the following: 1.By-law B-l Revised Amended: By-law B-l revised of the Minimum Wage Commission, enacting a levy, adopted by the Commission on November 27, 1940, approved by the Lieutenant-Governor in Council on December 13, 1940, by Order in Council No.4330, published in the Quebec Official Gazette on December 28, 1940, and subsequently amended, is again amended as follows : A) Section 5 of said By-law is amended by adding the following sub-section: \u2022However, for employers of timber-driving undertakings, said levy is exacted on the wages paid during each calendar year to their employees occupied at such work; and for employers of other forest, operations, said levy is exacted on the wages paid to their employees occupied at such work during each of the periods included between Mav first of one vear to April thirtieth next.\" B) Section 0 of said By-law, amended by Bylaw of Amendment of January 22, 1943, is again amended by adding after the first subsection of said section, the following: \"c) for the levy exacted from employers of timber-driving operations: February 10th of each year; d) for the levy exacted from employers of forest operations: June 10th of each year.\" 2.Coming into force: The present By-law shall come into force on the day of its publication in the Quebec Official Gazette.Passed and dated in the city of Quebec this first day of the month of June, in the year one thousand nine hundred and forty-three.[Seal] (Signed) Ferdinand Roy, President, \" Gus.Francq, Vice-President, \" J.A.Bouthillette, Members.\" H.Loudin, B.E.Brais.True copy, J.E.SIMARD, General Secretarv.3998-0 Département de l'Instruction publique Department of Education N° 290-43 .No.290-43 Québec, le 14 juin 1943.Quebec, June 14, 1943.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE SCHOOL MUNICIPALITY Demande est faite d'ériger une municipalité Application is made to erect a separate school scolaire distincte sous le nom de \"Saint-Paulin- municipality, under the name of \"Saint-Paulin- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 190, No.g#, Vol.75 1173 Dalibaire\" dans le comté de Matane, qui comprendra le territoire suivant, savoir: \"Les lots suivants, tous inclusivement, du canton de Dalibaire : 30 à 02 du rang Y, 29 à 58 du rang VI.26 à 00 du rang VII, 19 à 50 des rangs VIII, IX et X.Les lots suivants, tous inclusivement, du canton de Romieu : 34 à 51 du rang Y, 37 à 48 du rang VI, 40 à 51 du rang VU\".3945-25-2-0 Secrétaire.Dalibaire\", in the County of Matane, which will comprise the following territory, to wit: \"The following lots, all inclusively, of the Township of Dalibaire: 30 to 02 of Range V, 29 to 58 of Range VI, 25 to 00 of Range VII, 19 to 50 of Ranges VIII, IX and X.The following lots, all inclusively, of the Township of Romieu : 34 to 51 of Range V, 37 to 48 of Range VI, 40 to 51 of Range VII.\" 3945-25-2 Secretary.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Edgar Rochette, ministre du Travail, donne avis par les présentes et ce, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103), que le Syndicat national catholique de l'industrie de la boulangerie, de la patisserie et de la biscuiterie, inc., section de Québec, lui a présenté une requête à l'effet d'apporter des modifications au décret numéro 781, du 29 mars 1941, relatif au métier de boulanger, dans la cité de Québec, la cité de Levis, la ville de Québec-Ouest, les comtés de Québec, Québec-Ouest, Levis, Reauce, Montma-gny et Montmorency, excepté l'Ile d'Orléans: On demande les modifications suivantes: 1.\u2014Que l'alinéa suivant soit ajouté au paragraphe \"a\" de l'article V: \"Nonobstant les dispositions précédentes, la durée hebdomadaire du travail pour les contremaîtres-boulangers et les compagnons-boulangers sera de soixante (00) heures dans la zone I et de soixante-dix (70) heures dans la zone II.\" 2-Que les montants de \"$24.00\" et \"$21.00\" mentionnés à l'article VII du décret soient remplacés par \"£25.00\" et \"§22.00\" respectivement.3.\u2014Que les mêmes montants de \"$24.00\" et \"$21.00\" mentionnés au paragraphe \"e\" de l'article VIII soient également remplacés par \"$25.00\" et \"$22.00\" respectivement.4.\u2014Que le montant de \"$24.00\" mentionné à l'article IX soit remplacé par \"$25.00\".5.\u2014Que le montant de \"$19.55\" mentionné à l'article XVII soit également remplacé par \"$20.55\".6\u2014 Que les montants de \"$19.55\" et \"$17.00\" mentionnés à l'article XIV du décret soient remplacés par \"$20.55\" et \"$18.00\" respectivement.Le Conseil régional du travail en temps de guerre de Québec a autorisé la mise en vigueur desdits amendements, à sa séance du 10 juin 1943.Durant les trente jours, à compter de la date de la publication de cet avis, l'honorable ministre du Travail recevra les objections que les intéressés peuvent désirer formuler contre ladite requête.Le sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 26 juin 1943.3987-0 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Edgar Rochette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité Department of Labour NOTICE OF MODIFICATION The Honourable Edgar Rochette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163), that \"Le Syndicat national catholique de l'industrie de la boulangerie, de la patisserie et de la biscuiterie, inc., section de Québec\", has presented to him a request to modify the decree number 781, of March 29,1941, relating to the baker trade in the city of Quebec, the city of Levis, the town of Québec-Ouest, the counties of Quebec, Québec-Ouest, Levis, Beauce, Montmagny and Montmorency, with the exception of the Island of Orleans: It is requested : 1.\u2014That the following paragraph be added to subsection \"a\" of section V: \"Notwithstanding the foregoing provisions, the weekly duration of labour for baker-foremen and baker-journeymen shall be sixty (60) hours in Zone I and seventy (70) hours in zone II.\" 2.\u2014That the amounts of \"$24.00\" and \"$21.00\" mentioned in section VII of the decree be replaced by \"$25.00\" and \"$22.00\" respectively.3.\u2014That the same amounts of \"$24.00\" and \"$21.00\" mentioned in subsection \"e\" of section VIII be also replaced by \"$25.00\" and \"$22.00\" respectively.4.\u2014That the amount of \"$24.00\" mentioned in section IX be replaced by \"$25.00\".5.\u2014That the amount of \"$19.55\" mentioned in section XVII be also replaced by \"$20.55\".0.\u2014That the amounts of \"$19.55\" and \"$17.00\" mentioned in section XIV of the decree be replaced by \"$20.55\" and \"$18.00\" respectively.The Regional War Labour Board for Quebec has authorized the enforcement of the said amendments, at its meeting of June 16, 1943.During the thirty days following the date of publication of this notice, the Honourable Minister of Labour shall receive any objection against the said request which the interested parties may desire to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 26, 1943.3987-o NOTICE OF LEVY ?The Honourable Edgar Rochette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Com- 1174 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 190, No 26, Vol.76 paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district, établi en exécution du décret numéro 1742, du 11 juillet 1941 et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1052 «lu 23 juin 1943, le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 108), I prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La |>ériode de cotisation s'étend du 24 juin 1943 au 24 juin 1944 et s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels assujettis au décret doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à % de 1 % des salaires payés à leurs employés.6) Les artisans régis par le décret doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à Vi de 1 % du salaire établi pour le salarié le moins rémunéré, a savoir $16.80 par semaine.c) Les salariés assujettis au décret doivent verser au comité paritaire une somme équivalente a Yi de 1 % de leur salaire.2.Mode de percept ion En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport indiquant les heures de travail, les salaires payés au cours de la semaine, et les sommes versées au comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au comité paritaire tous les mois.Lorsque la dernière semaine d'un mois n'est pas complète, c'est-à-dire lorsque le dernier du mois tombe un jour autre que le samedi, cette partie de semaine fait partie du mois suivant pour les fins de la cotisation.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent au comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au comité paritaire.Ce comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Les cotisations doivent être payées au comité paritaire le ou avant le 0 du mois subséquent et doivent être accompagnées du rapport.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 30 septembre et 31 décembre 1943, 31 mars et 30 juin 1944.Est annexé à la présente requête, un état des recettes et des dépenses prévues du comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district, pour la période finissant le 24 juin 1944.Le comité paritaire de l'industrie de l'automobile de montréal et du district 701 ouest, rue Ste-Catherine\u2014Montréal Estimé des recettes et des déboursés pour la péri(xle comprise entre le 24 juin 1943 et le 24 juin 1944.mittee of the Automobile Industry of Montreal and District, formed under decree number 1742.of July 11, 1941, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number I6\">2, of .lune 23, 1943, in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 103), to collect levies from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the following method and rate: 1.Levy The period of levy extends from June 24, 1943 to June 24, 1944 and applies as hereinafter mentioned: a) The professional employers governed by the decree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi of 1% of the wages paid to their employees.6) All the artisans subject to the decree must also pay to the Parity Committee, Y2 of 1% of the lowest wage rate established for employees, namely $10.80 |>er week.c) The employees governed by the said decree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi of 1% of their wages.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these levies, the Parity Committee shall furnish the professional employers and the artisans with printed forms indicating the hours of labour, the wages paid during the week and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall have these reports filled and returned to the Parity Committee every month.When the last week of a month is not complete, that is when the last day of the month is not a Saturday, that part of the week shall, for the purposes of the levy, belong to the following month.The professional employer shall collect at the end of each week from the wages of every one of his employees the sums owed to the Parity Committee.The report of every professional employer must be signed before it is sent to the Parity Committee.This Committee has the right to exact sworn reports every time it deems it advisable.The report together with levies must be sent to the Parity Committee on or before the 0th of the following month.3.Financial report Pursuant to the provisions of section 21 of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: September 30 and December 31, 1943, March 31 and June 30, 1944.Hereto annexed is an estimate of the probable receipts and disbursements of the Joint Committee of the Automobile Industry of Montreal for the period ending June 24, 1944.The Joint Committee of the Automobile Industry of Montreal and District 761 St-Catherine West\u2014Montreal Estimate of the receipts and disbursements for the period between June 24, 1943, and June 24, 1944. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 190, No.26, Vol.75 1175 Recettes: Cotisations: (l/2 de 1 %): Employeurs professionnels.$ 11 ,044.43 Artisans.2,241.52 Salariés.11,«44.42 * 25,530.37 Dépenses: ¦.- Audition.$ 440.00 Échange et charges de banque.5.00 Dé|)enses générales.500.00 \\ssuranees.131.55 Frais légaux.900.00 Éclairage.120.25 Papeterie et divers.1,500.00 Organisation et propagande.2,000.00 Loyer.1,200.00 Salaires: Inspecteurs.14,470.00 Direction et personnel du bureau.12,100.00 Timbres.594.88 Taxes\u2014Cité de Montréal.03.00 Téléphone.315.89 A ssurance-ehômage.150.00 Jetons de présence: \u2022 Comité paritaire.1,020.00 Sous-comité de Réclamation.800.00 Sous-comité de Finance.300.00 Dépenses de voyage: Inspecteurs.3,200.00 * «39,870.57 Déficit estimé pour la période.S 14,340.20 11 est «à noter que nonobstant le déficit prévu, la réserve spéciale accumulée depuis le mois d'août 1938 sera plus que suffisante pour le combler.Le sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 20 juin 1943.3996-o Receipts: Levies: of 1%): Professional employers.S11,044 .43 Artisans.2,241 .52 Employees.11,«44.42 $25,530 37 Expetises: ===== Audition.$ 440.00 Exchange and Bank charges.5.00 ( Jeneral expenses.500.00 Insurances.131.55 Ix>gal charges.900.00 Lighting.120.25 Stationery and miscellaneous.1,500.00 Organization and publicity.2,000.00 Rent.1,200.00 Salaries* Inspectors.14,476.00 Management and office staff.12,100.00 Stamps.594.88 Taxes\u2014City of Montreal.63.00 Telephone.315.89 Unemployment insurance.150.00 Meeting expenses: Joint Committee.1,020.00 Claims sub-committee.800.00 Finance sub-committee.300.00 Travelling expenses: Inspectors.3,200.00 $39,876.57 Probable deficit for the period____: .$14,346.20 It should be noted that the special reserve made since the month of August 1938, shall be more than sufficient to cover the said probable deficit.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 20, 1943.3990-o Examens du Barreau\u2014Bar Examinations BARREAU DE MONTRÉAL.\u2014BAR OF MONTREAL.Candidats pour l'admission à l'étude du droit.\u2014Candidates for the admission to the study of law.Examen du C juillet 190,\u2014Examination.July 6, 1943.Noms V rimes Pronoms Surnames Arc Résidence Résidence Collèges Colleges L\u2014 3.4.-5.6.7.-8.-9.10.-11.12.-13.-14.15.lti.17.Houdreau Bourassa.Brassard.Décary.Deschênes Emery.Fabien Célinas.Genest.Grenier.Lacoste.Martineau Page.Parent.Perdriau.Raymond.Séguin.René.Maurice.Jean-M.Raymond G Jules.Cîeorges.André.Paul.Guy.Gabriel.Paul.Pierre G____ Robert.Luc.Jehan.Gaétan.Jean-C.26 20 21 21 19 19 20 17 19 21 20 18 19 19 21 21 20 Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Collège Ste-Marie.Collège Ste-Marie.Collège L'Assomption.Collège Jean de Brébeuf.Sém.de philosophie.Collège Ste-Marie.Collège Ste-Marie.Collège Jean de Brébeuf.Collège Jean de Brébeuf.Collège Ste-Marie.Sém.de philosophie.Sém.de philosophie.Collège Jean de Brébeuf.Collège Jean de Brébeuf.Collège Ste-Marie.Collège Ste-Marie.Collège de l'Assomption.Montréal, le 21 juin 1943\u2014Montreal, June 21st, 1943.3979-26-2- Le secrétaire du Barreau de Montréal, PAUL DURANLEAU, Secretary of the Bar of Montreal. 1176 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 190, No 26, Vol.75 BARREAU DE MONTRÉAL.-\u2014BAR OF MONTREAL CANDIDATS POUR L'ADMISSION À LA PRATiqi K DU DROIT.\u2014CANDIDATES ï'OK TIIK ADMISSION TO THK Pli Aertoire et index de Me Ronzo-Heathcote Clerk, notaire, demeurant et pratiquant à Montréal, district judiciaire de Montréal, qui a cessé tie pratiquer comme tel.Québec, ce 25 mai 1943.Le sous-secrétaire de la Province, 3801-22-5-o JEAN BRUCHESI.Avis est par le présent donné, conformément aux dispositions du Code du Notariat, qu'une requête a été présentée à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil par monsieur Georges Amable Deslandes, notaire, demeurant et pratiquant à Acton-Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, par laquelle il demande la transmission, en sa faveur, des minutes, répertoire et index de feu Joseph-Louis-Onésime Deslandes, en son vivant notaire à Acton-Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, et de ceux du notaire Hubert Lippe, dont Me.Joseph-Louis Onésime Deslandes était cessionnaire.Québec, ce 25 mai 1943.Le sous-secrétaire de la Province, 3802-22-5-o JEAN BRUCHESI.Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, et par commissions, de faire les nominations suivantes : Québec, 3 mars 1943.M.Roland Bélanger, agent d'assurances, 2523 rue Sheppard, Montréal: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Montréal, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).Québec, 6 mai 1943.MM.Nelson Asselin et Roger Beauvilliers, tous deux médecins: médecins-hygiénistes au have been issued by the Lieutenant-Governor of (lie Province of Quebec, hearing date the ninth day of June, 1943, changing the name of \"L'Association des Marchands de Bois de Montréal\" \"Montreal Lumber Dealers Association\", incorporated by letters patent bearing date the eleventh day of June, 1940, under the name of \"L'Association des Marchands de Bois de Montréal\"- \"Montreal Lumber Dealers Association\", to that of: \"Association des Manufacturiers & Marchands de Bois du Québec\"- \"Province of Quebec Lumber Dealers & Manufacturers Association\".Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1943.P.FRENETTE, 3992 Assistant Deputy Attorney General.Notarial Minutes Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Notarial Code, that a petition has been presented to His Honour the Lieutenant-Governor in Council by Mr.William Manly Bourke, Notary, residing at Westmount and practising at Montreal, judicial district of Montreal, whereby he asks for the transfer, in his favour, of the minutes, repertory and index of Me.Ronzo Heathcote Clerk, Notary, residing and practising at Montreal, judicial district of Montreal, who has ceased to practise as such.Quebec, May 25th, 1943.JEAN BRUCHESI, 3801-22-5 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Notarial Code, that a petition has been presented to His Honour the Lieutenant-Governor in Council by Mr.Georges Amable Deslandes, notary, residing and practising at Acton-Vale, judicial district of Saint-Hyacinthe, whereby he asks for the transfer in his favour of the minutes, repertory and index of the late Joseph-Louis-Onésime Deslandes, in his lifetime notary, at Acton-Vale, judicial district of Saint-Hyacinthe, and of those of Notary Hubert Lippe, whereof Me Joseph-Louis Onésime Deslandes was assignee.Quebec, May 25th, 1943.JEAN BRUCHESI, 3802-22-5 Under Secretary of the Province.Appointments His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by commission, to make the following appointments: Quebec, March 3rd, 1943.Mr.Roland Bélanger, insurance agent, 2523 Sheppard street, Montreal: to be a Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Montreal, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q.1941, chapter 15).Quebec, May 6th, 1943.Messrs.Nelson Asselin and Roger Beauvilliers, both physicians: to be hygienists in the service QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 190, No.26, Vol.75 1179 service dll Ministère (le la Santé et du Bien-Être Social.Québec, 31 mai 1943.M.Gaston Lamarre, B.S.A., employé civil, 129 rue Wright, Hull, P.Q.: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur les districts judiciaires de Hull, Montcalm, Terrebonne, Pnntiac, Rouyn-Xoran-da et Témiscamingue, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).Québec, 9 juin 1943.M.Roméo-Onésime Deslauriers, représentant du Service sélectif national, 2422 rue Ful-lum, Montréal: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur toute la province de Québec, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).M.Joseph-Rosaire Lemay, entrepreneur de pompes funèbres, 25 est, rue Laurier, Montréal: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Montréal, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.H.Q., 1941, chapitre 15).M.A.-F.Lamoureux, comptable vérificateur, 3755 rue Berri, Montréal: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur toute la province de Québec, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).M.J.-Alphonse Vallerand, comptable, 271^ Grande-Allée, Québec: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Québec, conformé* ment aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).Québec, 11 juin 1943.M.Herménégilde Savard, sacristain, St-AI-ban, comté de Portneuf: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Québec, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).M.J.-L.-E.Lavallée, contremaître au C.X.R., 4426 rue St-Jacques, Montréal: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Montréal, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).Québec, 12 juin 1943.M.J.-Antonio Fournier, du bureau du Service sélectif, Rivière-du-Loup: juge de paix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Kamou-raska, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).M.H.-H.Lemieux, marchand de glace, 230 rue St-Georges, Lévis: juge de paix aux fins tie recevoir le serment seulement, avec juridiction sur le district judiciaire de Québec, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).Québec, 16 juin 1943.M.J.-Bte Milette, secrétaire-gérant du Comité paritaire de l'industrie de la construction de of the Department of Health and Social Welfare.Quebec, May 31st, 1943.Mr.Gaston Lamarre, B.S.A., civil employee, 12!) Wright street, Hull, P.Q.: to be a Justice of the Peace for the purpose of administering the oath oidy, with jurisdiction over the judicial districts of Hull, Montcalm, Terrebonne, Pon-tiac, Rouyn-Noranda and Témiscamingue, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q.1941, chapter 15).Quebec, June 9th, 1943.Mr.Roméo-Onésime Deslauriers, representing the National Selective Service, 2422 Fullum street, Montreal: to be a Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction throughout the Province of Quebec, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (RS.Q.1941, chapter 15).Mr.Joseph-Rosa ire Ijcmay, funeral undertaker, 25 Laurier street East, Montreal: to be a Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Montreal, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q.1941, chapter 15).Mr.A.F.Lamoureux, auditing accountant, 3755 Berri street, Montreal: to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the whole Province of Quebec, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1941, chapter 15).Mr.J.Alphonse Vallerand, accountant, 271^ Grande-Allée, Quebec: to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Quel>ee, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1941, chapter 15).Quebec, June 11th, 1943.Mr.Herménégilde Savard, sacristan, St-Al-ban, County of Portneuf: to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Quebec, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1941, chapter 15).Mr.J.L.E.Lavallée, foreman Ln the C.N.R., 4426 St.James street, Montreal: to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Montreal, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1941, chapter 15).Quebec, June 12th, 1943.Mr.J.Antonio Fournier, of the Selective Service Bureau, Rivière-du-Loup: to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Kamouraska, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1941, chapter 15).Mr.H.H.Lemieux, ice merchant, 230 St-Georges street, Levis: to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the judicial district of Quebec, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice- Act (R.S.Q., 1941, chapter 15).Quebec, June 16th, 1943.Mr.J.Bte Milette, secretary-manager of the Joint Committee of the Building Trade of Sorel, * 1180 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 190, No 26, Vol.75 Sorel, ii Sorel: juge de puix aux fins de recevoir le serment seulement, avec juridiction sur toute la province de Québec, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1941, chapitre 15).4001-o Proclamations Canada, Province de EUG.FISET Québec.1L.S.] GEORGE VI, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, défenseur de la foi, empereur des Indes.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner,\u2014Salut.PROCLAMATION L.Désilets, \"i A TTENDU que les dis-Assistant-procurcur / positions de l'art i- général./ ticle 10 de la Loi des bureaux d'enregistrement (StatutsRefondus 1941, chapitre 319) permettent au lieutenant-gouverneur en conseil d'appliquer, par proclamation, quand il le juge il propos, :\\ toute division d'enregistrement, les dispositions des articles 2 et suivants de ladite Loi des bureaux d'enregistrement relatives à certaines divisions d'enregistrement dont le registrateur reçoit le traitement qui lui est assigné, conformément aux dispositions de la Loi du service extérieur (Statuts Refondus 1941, chapitre 12); Attendu qu'il est à propos d'appliquer, à la division d'enregistrement N° 2 de Nicolet, les dispositions desdits articles.A CES CAUSES, de l'avis et du consentement de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans l'or-dre-en-conseil N° 1629 du 19 juin 1943, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que, à compter du premier juillet 1943, les dispositions des articles 2 et suivants de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts Refondus 1941, chapitre 319) seront applicables à la division d'enregistrement N° 2 de Nicolet.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre Province de Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé le Major-Général l'honorable Sir Eugène-Marie-Joseph Fiset, Kt., C.M.G., D.S.O., M.D., lieutenant-gouverneur de Notre dite province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt et unième jour de juin en l'année mil neuf cent quarante-trois de l'ère chrétienne et de Notre Règne la septième année.Par ordre, Le sous-secrétaire de la Province, 3993-0 JEAN BRUCHESI.at Sorel : to be Justice of the Peace for the purpose of administering the oath only, with jurisdiction over the whole Province of Quel>ec, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Aet (R.S.Q., 1941, chapter 15).4001 Proclamations Canada,* Province of EUG.FISET Quebec.[L.S.] GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.\u2014Gheetings.PROCLAMATION L.Désilets, J YV/HEllEAS the provi-Deputy Attorney / vv sions of section lOofthe General.> Registry Office Act (Revised Statutes 1941, chapter 319) permit the Lieutenant-Governor in Council to extend, by proclamation, whenever he deems it expedient, to any registration division, the provisions of sections 2 and following of the said Registry Office Act respecting certain registration divisions whereof the registrar receives the salary assigned to him, in accordance with the provisions of the Outside Service Act (Revised Statutes 1941, chapter 12) ; Whereas it is expedient to extend, tô the registration Division No.2 of Nicolet, the provisions of the said sections.THEREFORE, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in the Order in Council No.1629 of the 19th of June, 1943, We have enacted and ordered and, do hereby enact and order that, from and after the first of July, 1943, the provisions of sections 2 and following of the Registry Office Act (Revised Statutes 1941, chapter 319) shall be applicable to the registration division No.2 of Nicolet.| Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major General, the Honourable Sir Eugène-Marie-Joseph Fiset, Kt., C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this twenty-first day of June, in the year of Our Lord nineteen hundred and forty-three and the Seventh year of Our Reign.By command, JEAN BRUCHESI, 193 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 190, No.26, Vol.75 1181 Canada, lWincede BUG.FI8ET Quebec.[LAI GEORGE VI, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, défenseur de la foi, empereur des Indes.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner,\u2014Salut.PROCLAMATION L.Désilets, | A TTENDU que, par ar-Assistant-proi-urcur> ** rêté en Conseil du 25 général.t septembre 1942, en vertu de la Ix)i des mesures de guerre, le Gouvernement canadien a décrété que la fête du Dominion serait le premier lundi de juillet; Attendu que la Législature de cette province a adopté la Loi modifiant la Loi concernant les statuts, sanctionnés le 80 mars_1943,£qui décrête, à l'article 1, ce qui suit: \"1.\u2014Le paragraphe 24° de l'article 61 de la Loi concernant les statuts, (Statuts refondus, 1941, chapitre 1), est mqdifié en remplaçant le paragraphe e) par le suivant: \"e) Le premier lundi de juillet, fête du Dominion;\" Attendu que cette Législature a aussi adopté la Loi modifiant le Code de procédure civile, sanctionnée le 20 mai 1943, qui décrète, à l'article 1, ce qui suit: \"1.\u2014L'article 7 du Code de procédure civile, modifié par l'article 2 de la Loi 2, Edouard VII, chapitre 12 et l'article 2 de la Loi 24, George V, chapitre 74, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 5 par le suivant : \"5.\u2014Le premier lundi de juillet.\"; Attendu que par arrêté en Conseil du 7 juin 1943, en vertu de la Loi des mesures de guerre, le Gouvernement canadien a décrété que la fête du Dominion serait le premier juillet; Attendu que l'article 2 de la Loi modifiant la Loi concernant les statuts, sanctionnés le 30 mars 1943, décrète ce qui suit: \"2.\u2014Le Lieutenant-Gouverneur pourra, par proclamation, décréter l'abrogation de la présente loi, à compter de la date qu'il jugera â propos de fixer.Cette abrogation aura l'effet de rétablir la disposition remplacée par la présente loi comme si la présente loi n'avait jamais été adoptée.\"; Attendu que l'article 16 de la Loi modifiant le Code de procédure civile, sanctionnée le 20 mai 1943, décrète ce qui suit: \"16.\u2014Le Lieutenant-Gouverneur pourra, par proclamation, décréter l'abrogation de l'article l de la présente loi il compter de la date qu'il jugera â propos de fixer.Cette abrogation aura l'effet de rétablir la disposition remplacée par ledit article comme si la présente loi n'avait jamais été adoptée.\"; Attendu qu'il y a lieu de décréter l'abrogation de la Loi concernant les statuts, sanctionnée le 30 mars 1943 et de l'article 1 de la Loi modifiant le Code de procédure civile, sanctionnée le 20 mai 1943, à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de Québec de la proclamation émise à ces fins.A CES CAUSES, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif exprimés dans l'ordre en conseil N° 1614 du 17 juin courant, Nous avons décrété et ordonné, et, par les présentes, décrétons et ordonnons l'abrogation de la Loi modifiant la Loi concernant les statuts, sanctionnée le 30 mars Canada, Province of EUG.FI8ET Quebec.[LB.] GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Kino, Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.\u2014Greetings.PROCLAMATION L.Désilets, \\ \"w/HEREAS, by Order in Deputy Attorney^ vv Council of September General.) 25th, 1942, the Canadian Government, pursuant to the War Measures Act, enacted that Dominion Day would be the first Monday of July; Wheheas the Legislature of this Province adopted the said Act amending the Act respecting the statutes sanctioned on March 30th, 1943, enacting, at section 1, as follows: \"1.\u2014Paragraph 24 of section 61 of the Interpretation Act (Revised Statutes 1941, chapter 1) is amended by replacing paragraph e) by the following: \"e) The first Monday in July, Dominion Day;\" Whereas this Legislature also adopted the Act amending the Code of Civil Procedure, sanctioned on May 20th, 1943, enacting, at section 1, as follows: \"1.\u2014Article 7 of the Code of Civil Procedure, as amended by the Acts 2 Edward VII, chapter 12, section 2, and 24 George X, chapter 74, section 2, is again amended by replacing paragraph 5 thereof by the following: \"5.\u2014The first Monday of July.\"; Whereas by Order in Council of June 7th 1943, pursuant to the War Measures Act, the Canadian Government enacted that Dominion Day would be the first of July; Whereas section 2 of the Interpretation Act, sanctioned on March 3rd, 1943, enacts as follows: \"2.\u2014The Lieutenant-Governor may, by proclamation, decree the repeal of the present Act, as from such date as he may deem proper to fix.Such repeal shall have the effect of re-establishing the provision replaced by this Act, as if this Act had never been passed\"; Whereas section 16 of the Act amending the Code of Civil Procedure, sanctioned on May 20th, 1943, enacts as follows: \"16.\u2014The Lieutenant-Governor may, by proclamation, decree the repeal of section 1 of this Act as from such date as he may be pleased to fix.Such repeal shall have the effect of reestablishing the provision replaced by the said section as if this Act had never been passed\"; Whereas it is expedient to enact the repealing of the Interpretation Act sanctioned on March 30th 1943 and of section 1 of the Act amending the Code of Civil Procedure sanctioned on May 20th 1943, from and after the date of publication, in the Quebec Official Gazette, of the proclamation issued to that effect.THEREFORE, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in Order in Council No.1614, of the 17th of June instant, We have enacted and ordained, and do hereby enact and ordain the repealing of the Interpretation Act, sanctioned on March 30th, 1943, and 1182 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 190, No 26, Vol.76 194.1, et de l'article 1 de la Loi modifiant le Code de procédure civile, sanctionnée le 20 mai 1943, à compter de la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujet* et tous autres (pie les présentes |>euvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre Province de Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé le Major-Général, l'honorable Sir Eugène-Marie-Joseph Fiset, Kt., C.M.G., D.S.O., M.D., lieutenant-gouverneur de Notre dite province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Qulbee, ce dix-septième jour de juin en l'année mil neuf cent quarante-trois de l'ère chrétienne et de Notre Règne la septième année.Par ordre, Le sous-secrétaire de la Province.3994-0 JEAN BRUCHESI.VENTES PAR LES SHÉRIFS of section 1 of the Act amending the Code of Civil Procedure, sanctioned on May 20th, 194;i, from and after the date of the present proclamation in the Quebec Official Gazi tit.Ok all of which Ouk loving subjects and all others whom these present may concern, are hereby required to take notice and to govern t hemselves accordingly.In testimony wheheof, We have caused these Our Letters to l>e made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major General, the Honourable Sir Eugène-Marie-Joseph Fiset, Kt., C.M.G., D.S.O.M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quelle, in Our Province of Quel>ec.this seventeenth day of June, in the year of Our Lord nineteen hundred and forty-three, and the Seventh year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHESI, 3994 Under Secretary of the Province.- i SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tel que mentionné plus bas.PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI ABITIBI Cour supérieure.\u2014District d'Abitibi Superior Court.\u2014District of Abitibi N°6266 I 1 A CORPORATION MUNI- No.6266 / '\"THE MUNICIPAL COR-Ç i-* CIPALE DE LA VILLE f 1 PORATION OF THE DE VAL DOR; versus HARRICANA GOLD TOWN OF VAL D'OR; versus HARRICANA MINES INCORPORATED 1939, dont le siège GOLD MINES INCORPORATED 1939, where-social est à Québec', à savoir: of the head office is at Quel>ec, to wit: Comme appartenant à la défenderesse les pièces As belonging to the defendant the parcels of de terre numéros soixante et un (61), soixante- land numbers sixty-one ((il), sixty-two (62), one deux (62), cent trente-quatre (134), cent trente- hundred and thirty-four (134), one hundred and sept (137), cent quatre-vingt-huit (188) et cent thirty-seven (137), one hundred and eighty-quatre-vingt-dix (190) subdivisions du lot origi- eight (188) and one hundred and ninety (190), naire numéro soixante et un (61) du Rang huit subdivisions of original lot number sixty-one (61) (8) du canton Dubuisson; les pièces de terre of Range Eight (8) of the Township Dubuisson ; numéros cent trente-trois (133), cent trente- the parcels of land numbers one hundred and quatre (134) et cent trente-sept (137) subdivi- thirty-three (133), one hundred and thirty-four sions du lot originaire numéro soixante-deux (62) (134) and one hundred and thirty-seven (137), du Rang huit (8) du même ranton ; les lots de subdivisions of original lot number sixty-two (62) terre numéros cent cinquante-huit (158), cent of Range Eight (8) of the same township; the cinquante-neuf (159), cent soixante (160) et lots of land numbers one hundred and fifty-cent soixante-dix (170) subdivisions du Bloc qua- eight (158), one hundred and fifty-nine (159), torze (14) du canton Bourlamaque et le Bloc one hundred and sixty (160) and one hundred numéro treize (13) du même canton de Bourla- and seventy (170), subdivisions of Block fourteen maque, le tout avec bâtiments y élevés, circons- (14) of the Township of Bourlamaque and Block tances et dépendances, seront vendus à la porte number thirteen of the said Township of Bourla-de l'église paroissiale de Val d'Or, MARDI le maque, the whole with buildings thereon erected.VINGT-SEPT JUILLET 1943, ft DIX heures circumstances and dependencies, will be sold at du matin.the parochial church door of Val d'Or, on TUESDAY the TWENTY-SEVENTH of JULY, 1943, at TEN o'clock in the forenoon.Le shérif, J.U.DUMONT, Cabinet du shérif, J.-U.DUMONT.Sheriff's Office, Sheriff.Amos, le 21 juin 1943.3985-26-2-0 Amos, June 21st, 1943.3985-26-2 [Première publication, 26 juin 1943] [First publication, June 26th, 1943] QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 26th, 1943, No.26, Vol.76 1183 BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour de Magistrat \u2014 Beauce N°2280 [ p BORGES ROY, fils d'Ho-) noré, cuit., de St-Romain, cté Frontenac, cessionnaire de Mtre Gérard La-courcière, avocat, Lac Mégantic, demandeur; vs DONAT PHILIPPE ROY, cuit., Ditchfield, Lac Mégantic, défendeur.\"Un certain morceau de terrain de quarante-trois (43) acres en superficie, plus ou moins, à être pris et détaché du lot de terre numéro six-A (ptie 6-a) dans le premier rang sur les plan et livre de renvoi officiels du canton de Ditchfield: borné au nord, par la ligne de division entre les lots six-A (six-a) et einq-B (5-b) du premier rang de Ditchfield; à l'est, par une route non encore verbalisée; au sud, par le terrain des représentants de Napoléon Boulet; il l'ouest, par le chemin allant de Mégantic à Woburn; le tout avec bâtisses, dessus construites, circonstances et dé-jiendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Ste-Agnès du I-ac Mégantic, Frontenac, le VINGT-SEPTIÈME jour de JUILLET 1943, à DIX heures de l'avant-midi.IjC sliérif Bureau du shérif, J.-P.GIGUERE.St-Joseph-de-Beauce, le 21 juin 1943.3986-26-2-0 [Première publication, le 26 juin 1943] HULL Cour Supérieure.\u2014District de Hull N° 7881 ( JOHN E.McCABE, marchand, J J Notre-Dame du Laus, Que., demandeur; vs PHILIPPE DEPOCAS, 85 rue Quinn, Longueuil, P.Q., défendeur.\"Toute cette propriété étant partie du lot 40B dans le rang 3 du canton de Bigelow, située sur le bord du lac Bigelow, à Notre-Dame du Laus, et mesurant 125 pieds de front par 125 pieds de profondeur, avec les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances\".Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de Notre-Dame du Laus, le NEUF JUILLET prochain, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif, Bureau du Shérif, I.ST-PIERRE.Hull, ce 29 mai, 1943.3842-23-2-0 [Première publication, 5 juin 1943] BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Magistrate's Court \u2014 Beauce No.2280 ( p EORGES ROY, son of Ho-) V-* noré, farmer, of St.Romain, County of Frontenac, assignee of Mtre Gérard Lacourcière, advocate, Lake Megantic, plaintiff; vs DONAT PHILIPPE ROY, farmer, Ditchfield, Lake Megantic, defendant.A certain parcel of land of forty-three (43) acres in area, more or less, to be taken and detached from lot of land number six-A (Pt.6-a) in the first Range, on the official plan and in the book of reference for the Township of Ditchfield; bounded on the North by the division line between lots six-A (6-a) and five-B (5-b) of the first Range of Ditchfield; on the East by a road not yet named, on the South by the land of the representatives of Napoléon Boulet ; on the West by the road leading from Megantic to Woburn; the whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the Parish of Ste.Agnès du Lac Megantic, Frontenac, on the TWENTY-SEVENTH day of JULY, 1943, at TEN o'clock in the forenoon.J.P.GIGUÊRE, Sheriff's Office, Sheriff.St-Joseph de Beauce, June 21st, 1943.3986-26-2 [First publication, June 26th, 1943] HULL Superior Court.\u2014District of Hull No.7881 ( JOHN E.McCABE, merchant, ) J Notre-Dame du Laus, Que., plaintiff; vs PHILIPPE DEPOCAS, 85 Quinn street, Longueuil, P.Q., defendant.All that property being a part of lot 40B in Range 3 of the Township of Bigelow, situate on the shore of Lake Bigelow, at Notre-Dame du Laus, and measuring 125 feet in front by 125 feet in depth\u2014with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Notre-Dame du Laus, on the NINTH of JULY next, at TWO o'clock in the afternoon.I.ST-PIERRE, Sheriff's Office, Sheriff.Hull, this 29th of May, 1943.3842-23-2 [First publication, June 5th, 1943] Vente pour taxes municipales Province de Québec CITÉ DE LACHINE Avis public est par le présent donné par le soussigné Emile Daoust, Greffier de la Cité de Lachine, que sous l'autorité de la Loi des Cités et Villes, S.R.Q.1941, les immeubles ci-après désignés, seront vendus à l'enchère publique, dans la salle des délibérations du Conseil, à l'Hôtel de Ville, dans la Cité de Lachine, le VINGT-DEUXIEME jour de JUILLET, mil neuf cent quarante-trois, à DIX heures de l'avant-midi, pour Taxes Municipales, Générales, Spéciales et Scolaires dues à ladite Cité, à moins que lesdites redevances municipales-et scolaires ne soient payées avec les frais encourus avant la vente.Sale for Municipal Taxes Province of Quebec CITY OF LACHINE Public notice is hereby given by the undersigned Emile Daoust, City Clerk of the City of Lachine, that under authority of the Cities' and Towns' Act, R.S.Q.1941, the immovables hereunder described will be sold by public auction, in the meeting room of the Council, at the City Hall, in the City of Lachine, the TWENTY-SECOND day of JULY, Nineteen Hundred and Forty-three, at TEN o'clock in the forenoon, for the General, Municipal, Special and School Taxes due to the said City, unless the said Municipal and School dues be paid with costs incurred before the sale. 1184 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 juin 190, No 26, Vol 75 Ville de Lachine \u2014 Town of Lachine il i m à à ]{* B S et\t1 i Ê C c\t% o H g ¦ O a* .il H < ce\t\t $\t|\t* 5kl 48\t30.03\t541 51 256.11\t10 74\t272.85 128.06\t8 59\t136.64 197.79\t0 52\t204.31 201 83\t10.28\t272.11 261.45\t10.28\t271.73 21 20\t.80\t22.00 66.28\t2 51\t67.79 17.58\t1 00\t18 58 17.59\t1 00\t18 59 17.60\t1 00\t18.60 17.59\t1 00\t18.59 18 99\t1 05\t20.04 19.01\t1.05\t20.06 16.53\t.95\t17.48 16 53\t95\t17.48 26.39\t1.47\t27.86 239.79\t8.36\t248.16 12 55\t.49\t13 04 13 95\t.54\t14.49 Propriétaires cot iscs Assessed proprietors 8/10 Suce.-Est, Doudaa \\v.Ogilvie, et/ou Suce.-and.'or Est.Alexandre Laplante, 7/10 John W.Eamon.3/10 Suco.-Eit.Douglas W.OgUvie, et/ou Suce.-ami or Bit, Alexandre Laplante, 7/10 John W.Eamon.3/10 Suce.-Est.DoUgUVR W.Ogilvie, et/ou Suce.-and/or Est.Alexandre Laplante, 7/10 John W.Eamon.4 Charles IL C'armiehael.i t Charles R.( 'arniiehael.Charles IL ('arniiehael.Dawes Thomas A., Sr, et.Suce.-and Est.James P.Duwes, et-anentiers-Me- nuisiers de Montréal.1167 Syndicat Professionnel des Institutrices Catholiques de la Cité de Qtlébee.1167 Chartes\u2014Abandon de: Canadian Cold Oi>erators Limited.1170 Insurance Exchange Barber Shop, Limited.1170 L'Aide Canadienne aux Combattants de Langue Française.1170 Prospectors Airways (Quebec) Company Limited.1170 Commission du Salaire Minimum: N° 35, 1942\u2014Établissements commerciaux d'alimentation au détail, cité de Québee et ville de Québec-Ouest.1171 Règlement B-l revisé édictant un prélèvement.1171 Départements \u2014 Avis des : Instruction publique: Saint-Paulin-Dalibaire, munie, scolaire.1172 Travail: Industrie de l'automobile de Montréal et du district.1173 Syndicat national catholique de l'industrie de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, inc., section de Québec.1173 Examens du Barreau: Bas St-Laurent: pratique du droit.1177 Montréal : étude du droit.1175 Montréal : examen oral.1177 Montréal : pratique du droit.1176 Québec : examen oral.1177 Québec : pratique du droit.1176 Trois-Rivières: pratique du droit.1176 Lettres patentes: B.Goodman Inc.1152 Canada Baskets Limitée\u2014Canada Baskets Limited.1153 La Société St-Jean Baptiste de Rouyn et de Noranda Incorporée.1153 L'Association de la Colonie de Vacances de Granby.1154 Montreal Fruit Receivers Association Inc.1154 Spearton Investments, Limited.1155 Lettres patentes supplémentaires: Association des Manufacturiers & Marchands de Bois du Québec\u2014Province of Quebec Lumber Dealers
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.