Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 12 juin 1948, samedi 12 (no 24)
[" Tomb 80, N# 24 1707 Vol.80, No.24 \u2022\t\t _\t\t *\t\t* (Drapeau de la province de Québec, adopté par arrêté en conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flag of the Province of Quebec adopted by Order in Council Number 72, bearing date January 21st, 1948.) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement DE la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 12 juin 1948 AVIS AUX INTÉRESSÉS Réglementa 1* Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2* Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.0° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7* La Gazette officielle ie Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OFDQUEBEC Quebec, Saturday, June 12th, 1948 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rule* 1.Adress all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Goutte is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorised, by the Canada Post Office, Otta-claase, Ministers das Postas, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 1708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U juin 19A8, Tome 80, N° 2L délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, Les avis, documents ou annonces reçus eh retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Itoi a le droit de retarder la publication de certains documents, cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont prié d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 ligues par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.IL\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RËDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.21991 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advcrtiying Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RËDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.21991 \u2014 1-52 Lettres patentes Albee Fruit Co.Inc.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze mai 1948, constituant en (orporation: Louis H.Rohrlick, C.R., avocat, Jessie Davine et Libby Turner, secrétaires, filles majeures, tous de' la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de fruits et légumes, sous le nom de \"Albee Fruit Co.Inc.\", avec un capital de $-10,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Letters Patent Mix¦»¦ Fruit Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1948, incorporating: Louis H.Rohrlick, K.C., advocate, Jessie Davine and Libby Turner, secretaries, spinsters, all of the city of Monti eal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of fruit and vegetable merchants, under the name of \"Albee Fruit Co.Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 12th, 1948, Vol.80, No.24 1709 Alexandre Duranceau Limitée Alexandre Duruuecuu Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté'par M.Alfred Mo-, risset, conformément à l'article 2, chapitre 276 S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du douze mai 1948, constituant en corporation: Alexandre Duranceau, entrepreneur-général, Jac-ques-P.St-Jacques, avocat, tous deux de la cité de Montréal, et Wilfrid Duquette, avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et constructeurs généraux, sous le nom de \"Alexandre Duranceau Limitée\" \u2014 \"Alexandre Duranceau Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 2,000 actions d'une valeur au pair de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1948.\u2022 L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Chateau Dyers Ltd.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la pren ière partie c'e la Loi des con pagnies f $100 each.The head office of the company will be at L'Assomption, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth «lay of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Les Immeubles Cimon, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, benring date the twenty-fifth day of May, 1948, incorporating: Joseph Alphonse Cimon, manufacturer, of the city of Outre-mont, Antoinette DesTroismaisons, secretary, spinster, and Charles Duval, notary, the two latter of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and industry of real estate, building, an«l that of contractors, under the name of \"Les Immeubles Cimon, Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 preferred shares of $100 each and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Les Laboratoires Pagnol Inc.Pagnol Laboratories Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May, 1948, incorporating: Louis Dussault, advocate, Pauline Boily, secretary, both of Quebec, Juliette Turcotte, secretary, of Giffard, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in all kinds of goods, products or objects, connected with the business of pharmaceutical and chemical products, subject to the provisions of the Quebec Pharmacy Act (R.S.Q.1941, c.267), under the name of \"Les Laboratoires Pagnol Inc.\" \u2014 \"Pagnol Laboratories Inc.\", with a capital stock divided into 900 Class A preferred shares of a par value of $50 each and 900 Class B preferred shares of a par value of $50 each and 1,800 common shares without nominal value.- The amount with which the company will begin its operations shall be $18,000.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General. 1712 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 12 juin 1918, Tome 80, N° 21 Lindy's Inc.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la piemière partie de la Loi des compagnies de Québec, il u été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze mai 1948, constituant en corporation: Isaac Fisehler, Charles Michels et Si Michels, marchands, de la cité de Montiéal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un marchand de friandises et le commerce d'un restaurant, cafétaiia, comptoir de repas légers, marchand de tabac; et le commerce de vêtements de toute description pour femmes, hommes et enfants, sous le nom de \"Lindy's Inc.\", avec un capital de $-10,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judicial!e de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Matelas Montréal (Incorporée) Montreul Mattress (Incorporated) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant -gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1948, constituant en corporation: Robert Martel, courtier, I bald Fortin, professeur, et Claude Martel, comptable, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, faire le commerce de toutes sortes de toile, coton, laine, soie, crin et autres substances convenables pour la fabrication de literie, coussins, oreillers, matelas et tous autres articles de nature semblable ou similaire; De toutes sortes de meubles et autres garnitures, sous le nom de \"Matelas Montréal (Incorporée)\"'\u2014 \"Montreal Mattress (Incorporated)\", Le capital actions de la compagnie consistera en 500 actions pri\\ ilégiées d'une valeui au pair de $10 chacune et 100 actions ordinaires sans valeur au pair ou non inale; Le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera d'au moins §1,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le d juze mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Merry \"Maid Fashions Inc.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro\\ ince de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze mai 1948, constituant en corporation: Max Crestohl, avocat, Olyve Harrison, secrétaire, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, et Riva Bernice Shatsky, secrétaire, fille majeure, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et généralement faire le commerce de vêtements pour hommes, femmes et enfants, sous le nom de \"Merry Maid Fashions Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 180 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 Lindy's Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1948, incorporating: Isaac Fischler, Charles Michels and Si Michels, merchants, of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To cairy on the business of a dealer of delicatessen products and the business of a restaurant, cafeteria, light lunch, tobacconist; and the business of women's men's and children's wearing apparel of every description, under the name of \"Lindy's Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common share;: of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Matelas Montreal (Incorporée) Montreal Maltic*tt (liu-«.r|)oiatcd) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have be en issued by the Lieutenant-Go\\einor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1948, incorporating: Robert Martel,broker, Ubald Fortin, professor, and Claude Martel, accountant, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, deal in all kinds of linen, coton, wool, silk, horse hair and other substances suitable for the manufacture of bedding, cushions, pillows, mattresses and any other articles of same or similar nature; Furniture of all kinds and other trimmings, under the name of \"Matelas Montréal (Incorporée)\"\u2014 \"Montreal Mattress (Incorporated)\".The capital stock of the company will consist of 500 preferred shares of a par value of $10 each and 100 common shares without par or nominal value; The amount with which the company will begin its operations shall not be less than $1,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of Mav, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Merry Maid Fashions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of Mav, 1948, incorporating: Max Crestohl, advocate, Olyve Harrison, secretary, spinster, of the full age of majority, both of the city of Montreal, and Riva Bernice Shatsky, secretary, spinster, of the city of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in wearing apparel for men, women and children, under the name of \"Merry Mad Fashions Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 180 preferred shares of a par value of $100 each, and 200 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 1M, 19A8, Vol.80, No.2A 1713 chacune et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Lf liègfl social de la Compagnie sera en la cité (le Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onse mai 1948.I,'Assistant-procureur général, L.DESILETS.Provincial Truck éi Itiis Equipment Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi-des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentee) en date du vingt -quatre mai 1948, constituant en corporation: Georges-René Founder, avocat, Georges Morin, gérant, et Annette Giguère, sténographe, tous de la cité de Québec, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer tous les pouvoirs et faire toutes les opérations du commerce de l'automobile, des voitures, des bateaux, des aéroplanes, des moteurs stationnaires ou mobiles, des remorques, ainsi que de tous les accessoires y afférent, sous le nom de \"Provincial Truck & Bus Equipment Company Limited\", avec un capital de S20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à 20.Le siège social de la compagnie scia à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1948.L'Assistant-piocurcur généial, L.DÉSILETS.common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of Mav, litis.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Provincial Truck *K Hun Equipment Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of May, 19-18, incorporating: Georges René Founder, advocate, Georges Mot in, manager, and Annette Giguère.stenographer, all of the city of Quebec, judicial district of Quebec, for the following purposes: To exercise all the powers and carry on all the Operations and business of automobiles, vehicles, boats, aeroplanes, stationary or mobile engines, trailers, and also any accessories connected therewith under the name of \"Provincial Truck & Bus Equipment Company Limited\", with a capital stock of 120,000 divided into 200 shares of $100 each.The number of shareholders of the company shall be limited to 20.The bead office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of Mav.1918.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Itoscmouiit Realties Limited Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept mai 194S, constituant en corporation: Ernest Carrère, Léo Davignon, Comptables, et Reginald Donald Tormey, avocat, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, bâtir, posséder, développer ou autrement faire le commerce et disposer de lots, terrains, sites, immeubles et propriétés réelles ou de tout intérêt en iceux, sorrs le nom de \"Rosemount Realties Limited\", avec un capital de S80.000 divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 6,000 actions privilégiées d'une valeur de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Sheffield Underwear Mills Ltd.w Avis est.par les présentes, donné qu'en vertu de la première partit\" de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le 1 ieutenant-gouverneur de la province de Québec, hs lettres patentes en date .lu douze mai 1948, constituant en corporation: Louis Orenstein, Jacob S.Wasser-nian.Bernard S.M?rgle.-, avocats, et Max Pad-hsr, comptable, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Kosemoiint Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1948 incorporating: Ernest Carrère, Léo Davignon, accountants, and Reginald Donald Tormey, lawyer, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire, build upon, hold, develop or otherwise deal in and dispose of lots, lands, sites, real estate and real property or any interest therein under the name of \"Rosemount Realties Limited\", with a capital stock of $80,000 divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each, and 6,000 pieferred shares of a value of $10 each.The head office ol the company will be at Montreal, judicial distiict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day cf May 1948.^ L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Sheffield Underwear Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor cf the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1948, incorporating: Louis Orenstein, Jacob S.Wasserman, Bernard S.Mergler, advocates, and Max Padber, accountant, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: 1714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 12 juin 1918, Tome 80, N° 2k Négocier ou faire le commerce de laine et de tissus de coton, lainages, soieries, toiles et vêtements de toute sorte, nouveautés, jouets, accessoires commerciaux et ménagers, sous le nom de \"Sheffield Underwear Mills Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social vie la compagnie sera I Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.To deal in or with wool and cotton fabrics, woollens, silks, linens and clothing of every sort, novelties, toys, commercial and household supplies, under the name of \"Sheffield Underwear Mills Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 2C0 common shares of $100 each, and 200 preferred shares at $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal; Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Sunrise Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du quatorze mai 1948, constituant en corporation: Fcr-nand Guertin, Gaston Lacroix, avocats, de la cité d'Outremont, et Jean Tellier, avocat, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer en général le métier et le commerce de constructeur, d'entrepreneur-général et tous autres commerces ou industries se rapportant à ceux-ci, sous le nom de \"Sunrise Construction Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Acquérir le commerce actuellement opéré à Montréal par \"Sunrise Enterprise Construction Company\".Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Vêtements Saguenay Ltée Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moiisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze mai 1948, constituant en corporation: Louis Abraham DeZwirek, avocat, de la cité de Montréal, Samuel Leon Mendelsohn, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de West-mount, et Bertha Mendelson, secrétaire, fille majeure, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce général d'habits et vêtements de toutes sortes pour femmes, demoiselles, hommes et garçons, sous le nom de \"Vêtements Saguenay Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicou-timi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Sunrise Construction Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of May, 1948, incorporating: Fernand Guertin, Gaston Lacroix, advocates, of the city of Outre-mont, and Jean Tellier, advocate, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the trade and business of builder, general contractor, and any other businesses or industries connected with same, under the name of \"Sunrise Construction Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.To acquire the business actually carried on at Montreal by \"Sunrise Enterprise Construction Company\".The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Vêtements Saguenay Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by M.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of May, 1948, incorporating: Louis Abraham DeZwirek, advocate, of the City of Montreal, Samuel Leon Mendelsohn, advocate and King's Counsel, of the City of Westmount, and Bertha Mendelson, secretary, spinster, of the City of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in generally, women's, misses', men's and boy's clothing and wearing apparel, of all kinds, under the name of \"Vêtements Saguenay Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 common shares of the par value of $100 each, and 100 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 12th, 19A8, Vol.80, No.£A 1715 Voloa Import-Export Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première paitic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du quinze mai 1948, constituant en corporation: Frank Pappas, pûtissier, Antoine Coutroulis, commerçant, et Katerini Coutroulis, épouse séparée de biens de Antoine Coutroulis d'après la Loi Grecque, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits et machines agricoles, matériaux de construction, outillage de tout genre, bois, charbon, produits miniers, minerais, tout produit alimentaire, sous le nom de \"Volos Import-Export Incorporée\", avec un capital de $30,000, divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaiie de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1948.L'Assistant-procureur général, 22390-o L.DÉSILETS.Voloa Import-Export Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of May, 1948, incorporating: FiankPappas,pastrycook, Antoine Coutroulis, trader, and Katerini Coutroulis, wife separate as to property of Antoine Coutroulis, according to the Greek Law, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in agricultural products and machines, building requisites, equipment of every kind, wood, coal, mining products, ore, all food products, under the name of \"Volos Import-Export Incorporée\", with a capital stock of $30,000, divided irrto 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.2239G TA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS EN LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ET DES INTERNES MÉDECINE ET DES INTERNES MÉDECINE Avis est donné qu'en verttr des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1948, constituant en corporation sans capital-actions: Lionel Pré-fontaine, étudiant en Médecine, de Prud'homme, Saskatchewan, Raymond-C.Bourgeois, médecin-interne, de Tracadie, Nouveau-Brunswick, Lionel Lemieux, médecin-interne, d'Ottawa, Ontario, Roland, Lauzon, étudiant en médecine, de Sudbury, Ontario, Jacques Roussel, étudiant en médecine, de Montréal, district judiciaire de Montréal, Georges Saulnier, médecin-interne, Roland Hould, André Potvin, étudiants-internes, de la cité de Québec, district judiciaire de Québec, Gérard-Georges Letcndre, étudiant-interne, de Danville, district judiciaire de Saint-François, Roland Bouliane, étudiant-interne, de Vallée-Jonction, district judiciaire de Beaucc, et André Gagnon, étudiant-interne, de Saint-Tite, district judiciaire des Trois-Rivières, tous pour les objets suivants : Associer dans un commun effort de perfectionnement professionel et de culture française des groupes canadiens d'étudiants-internes, d'étudiants en médecine non-internes et de médecins-internes; Acheter ou autrement acquérir les biens de \"La Fédération Canadienne des Étudiants en Médecine et des Internes\" et en noursuivre les entreprises, sous le nom de \"LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ET DES INTERNES\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de cinquante mille dollars.Le siège social de la corporation sera en la ville de Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1948.L'Assistant-procureur général, 22420-o .L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1948, to incorporate as a corporation without sliare capital: Lionel Préfontaine, medical student, of Prud'homme, Saskatchewan, Raymond C.Bourgeois, senior interne, of Tracadie, New Brunswick, Lionel Lemieux, senior interne, of Ottawa, Ontario, Roland Lauzon, medical student, of Sudbury, Ontario, Jacques Roussel, medical student, of Montreal, judicial district of Montreal, Georges Saulnier, senior interne, Roland Hould, André Potvin, junior internes, of the city of Quebec, judicial district of Quebec, Gérard Georges Letendre, junior interne, of Danville, judicial district of St.Francis, Roland Bouliane, junior interne, of Valley-Junction, judicial district of Beauce, and André Gagnon, junior interne, of Saint-Tite, judicial district of Trois-Rivières, all for the following purposes : To unite in a common effort for professional improvement and French culture of groups of medical students, junior internes, senior internes and residents; To purchase or otherwise acquire the assets of \"La Fédération Canadienne des Étudiants en Médecine et des Intîrncs\" and continue their undertakings under the name of \"La FEDERATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ET DES INTERNES\" The amount to which the immovable property which the corporation may possess is to be limited is fifty thousand dollars.The head office of the corporation will be in the city of Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, 22420 Deputy^Attorney General. 1716 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, M juin 1948, Tome 80, N° 24 Lettres patentes supplémentaires A.Fcldmail Compull} Avis est, pur lei présentes, donné qu'en vertu de lu premiere partie de lu Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur île la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt et un mai 1948, à la compagnie \"A.Pcldmun ( Ipmpany\" ratifiant son règlement N 23 augmentant son capital de $20,000 à $60,000 par la création de 400 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1048.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, American-European Fur Co.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutciiunt-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du dbemai 1948, à la compagnie \"American-European Fur Co.\", ratifiant son règlement N 22 augmentant son capital de $20,000 à $60,000 par la création de 200 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de $100 chacune et de 200 actions privilégiées d'une valeur au pair «le 8100 chacune et énumérant les privilèges attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le dix-mai 191 S.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Atlantic Steel Company Limited Avis est.par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du dix-neuf mai 1948, à la compagnie \"Atlantic Steel Company Limited\", ratifiant son règlement Xo.28 augmentant son capital de $69,900 à $138,900 par a création le 690 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et énumérant les privilèges attachés à ces actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Cycles \"Gachon\" Incorporée \"Gaehon*' Cycles Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 mai 1948, à la compagnie \"Cycles \"Gachon\" Incorporée\" \u2014 \"Gachon\" Cycles Incorporated\", ratifiant son Règlement No.20 subdivisant les 590 actions ordinaires de son capital d'une valeur au pair de $100 chacune, en 5,900 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et convertissnt les 150 actions privilégiées classe \"A\" et les 450 actions privilégiées classe \"B\" d'une valeur au pair de $100 chacune en 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune jouissant des privilèges mentionnés audit règlement.Daté du bureau du_E©>çureur général le 19 mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Supplementary Letters Patent A.Feldman Company Notice il hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 21st day of May.1948, were issued by the Lieutenant-Gj»\\crncr of the Province of Quebec to the company \"A.Fcldman Company\" ratifying its By-Law No.23 increasing its capital from 820,000 to $60,000 by t he creation of 400 additional cmnnon shares of the par value of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General the 21st of Mav, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General, American-European Fur Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.Supplementary letters patent bearing date the 10th day of May.194S, were issued by th:' 1 icutciianl-Go\\crnor of the Province of Qui bee to the Con pany \"American-European Fur Co.\" ratifying its By-Law No.22 increasing ils capital stock from $20,000 to 860,000 by th.' creation of 200 additional common shires of the par value of $100 each and of 200 pr< fcrred shares of the par value of $100 each, and enumerating the privileges attaching to the preferred shares.Dated at the office of the Attomcv General the 10th of Mav, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Atlantic Steel Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 19th day of May.1948, were issued by the Lieutenant-(io\\crnor of the Province of Quebec to the con pany \"Atlantic Steel Company Limited\", ratifying its By-Law No.28 increasing its capital from $69,900 to $138,900 by the creation of 690 preferred shares of the par value of $100 each, and enumerating the privileges attaching to these preferred shares.Dated at the office of the Attomcv Genera the 19th of Mav, 194S.L.DÉSILETS.Deputy Attorney General.Cycles \"Gachon\" Incorporée \"Gachon\" Cycles Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the nineteenth day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Cycles \"Gachon\" Incorporée\" \u2014 \"Gachon\" Cycles Incorporated\", ratifiying its By-law No.20, subdividing the 590 common shares of its capital stock of a par value of $100 each, into 5,900 common shares of a par value of $10 each, and converting the 150 Class \"A\" preferred shares and the 450 Class \"B\" preferred shares, of a par value of $100 each, into 600 preferred shares of a par value of $100 each, enjoying the privileges mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June VAh, 194$, Vol.SO, So.2L 1717 Intercity Airlines Company Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.H.Q.1911 des lettres patentes supplémentaires en date du vingt et un mai 1948, à la compagnie \"Intercity Ail lines Company\", ratifiant son règlement N° 19 augmentant son capital-actions autorisé par la création de 22,000 actions ordinaires additionnelles sans valeur nominal ou au pair et fixant le montant du capital avec lequel lu compagnie continuera d'exercer son commerce à $21)0,000.Daté du bureau du Prociueur général, le vingt et un mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, Montreal-New York Express Ltd.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies-de Québec, il a été accordé par le Lieutenant gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du dix-neuf mai 1948, à la compagnie \"Montreal-New York Express Ltd.\", ratifiant son règlement \"C\" augmentant son capital de $20,000 à $95,000 par la création de 7,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et énumérant les privilèges attachés auxditcs actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur générul, le dix-neuf mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Murray's Restaurants Limited Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt-sept mai 1948, changeant le nom de la compagnie **Murray's Lunch Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 avril 1926, en celui de \"Murray's Restaurants Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Patronage Roc-Amadour Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 mai 1948, changeant le nom de \"Patro Saint-Roch\", corporation constituée par lettres-patentes émises en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi le 11 janvier 1946, en celui de \"Patronage Roc-Amadour\".Daté du bureau du Procureur général le 26 mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.R.Guy (Eastern) Ltd.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec il a été accordé par le Lieutenant- Intercity Airlines Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 21st day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1911, to the company \"Intercity Airlines Company\", ratifying its By-law No.19 increasing its authorized share capital by the creation of 22,000 additional common shares without nominal or par value, and fixing the amount of capital with which the companv will continue to do business at $200,000.00 Dated at the office of the Attorney General the 21st of Mav, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Mont*eal»New York Express Ltil.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, beating date the 19th day of May, 1918, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"Montreal-New York Express Ltd.\", ratifying its By-Law \"C\" increasing its capital stock from $20,000 to 105,000by the creation of 7,500 preferred shares of the par value of $10 each, and enumerating the privileges attaching to the said preferred shares.Dated at the office of the Attornev General the 19th of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Murray's Restaurants Limited \u2022Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 27th day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Murray's Lunch Limited\", incorporated by letters-patent dated April 9th, 1946, into that of \"Murray's Restaurants Limited\".Dated at the office of the Attornev General the 27th of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney Guecral.Patronage Roc-Amadour Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-sixth day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of \"Patro Saint-Roch\" a cotpora-tion incorporated by letters patent issued under the provisions of Part LU of the said Act, on January 11, 1946, to that of \"Patronage Roc-Amadour\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of Mav, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney Gneeral.R.Guy (Eastern) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 20th day of May, 1948, 1718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.12 juin 19A8, Tome 80, N° SA gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt mai 1948, à la compagnie \"Quebec Converters Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 octobre 1941, ratifiant : 1°) son règlement N° N-l changeant le nom corporatif de la compagnie de \"Quebec Converters Limited\" en celui de \"R.Guy (Eastern) Ltd.\"; 2°) son règlement spécial N° S-l subdivisant et convertissant les 21 actions émises du capital de la compagnie d'une valeur au pair de $100 chacune en 210 «étions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et diminuant ledit capital en annulant les 179 actions ordinaires non-émises d'une valeur au pair de $10*0 chacune; 3°) son règlement spécial N° S-2 augmentant son capital ainsi diminué à $200,000 par la création de 4,790 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de $10 chacune et de 2,000 actions privilégiées catégorie \"A\" d'une valeur au pair de $25 chacune et de 4,000 actions privilégiées catégorie \"11\" d'une valeur au pair de $25 chacune et énumérant les privilèges attachés auxdites actions privilégiées catégories \"A\" et \"B\"; 4°) son règlement N° N-2 augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de trois à sept, lequel règlement N° N-2 se lit comme suit: \"1.Le bureau de direction de la compagnie Quebec Converters Limited est, par les présentes, augmenté «le trois à sept.2.Lé règlement N° 7 de la compagnie est modifiée en y rayant le mot \"trois\" où il apparait et en y substituant le mot \"sept\".Daté du buieau du Procureur général, le vingt mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.The Glove Knitters Inc.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du treize mai 1948, à la compagnie \"The Glove Knitters Inc.\", ratifiant son règlement N° 24 augmentant son capital de $40,000 à $90,000 par la création de 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et énumérant les privilèges attachés à ces actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"Quebec Converters Limited\", incorporated by letters patent dated October 22nd, 1941, ratifying: 1) its By-law No.N-l changing the corporate name of the company from \"Quebec Converters Limited\" to that of \"R.Guy (Eastern) Ltd\", 2) its Special By-Law No.S-l subdividing and converting the 21 issued shares of the capital stock of the company of the par value of $100 each into 210 shares of common stock of the par value of $10 each and reducing the said capital stock by cancelling the 179 unissued common shares of the par value of $100 each; 3) its Specie] By-Law No.S-2 increasing its capital stock as so reduced to $200,000 by the creation of 4,790 additional common shares of the par value of $10 each and of 2,000 Class \"A\" preferred shares of the par value of $25 each and of 4,000 Class \"B\" preferred shares of the par value of $25 each, and enumerating the privileges attaching to the said Classes \"A\" and \"B\" preferred shares; 4) its By-Law No.N-2 increasing the number of directors of the company from three to seven, which By-Law No.N-2 reads as follows: \"1.The Board of Directors of Quebec Converters Limited is hereby increased from three to seven.2.By-Law No.7 of the Company is amended by striking out the word \"three\" where it appears therein and substituting therefor the word \"seven\".Dated at the office of the Attorney General the 20th of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.The Glove Knitters Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 13th day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"The Glove Knitters Inc.\", ratifying its By-Law No.24 increasing its capital from $40,000 to $90,000 by the creation of 500 preferred shares of the par value of $100 each, and enumerating the privileges attaching to these preferred shares.Dated at the office of the Attorney General the 13th of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Tricots Lainari Incorporée Lainart Hosiery Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec,-» il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 mai 1948, à la compagnie \"Tricots Lainart Incorporée\" \u2014 \"Lainart Hosiery Incorporated\", ratifiant un règlement modifiant le capital-actions de la compagnie en changeant les 20,000 actions sans valeur au pair constituant ledit capital-actions en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 17 mai 1948.L'Assistant-procureur général, L.DESILETS, Tricots Lainart Incorporée Lainart Hosiery Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the seventeenth day of May, 1948, to the company \"Tricots Lainart Incorporée\" \u2014 \"Lainart Hosiery Incorporated\", ratifying a by-law modifying the capital stock of the company by changing the 20,000 shares without par value forming the said capital stock, into 20,000 common snares of a par value of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 12th, 19L8, Vol.80, No.2k 1719 \\ ill* ray Metallic Industries Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 mai 1948, à la compagnie \"Villeray Metallic Industries Limited\" étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général le 17 mai 1948.L'Assistant-procureur général, 22397-0 L.DÉSILETS.Villeray Metallic Industries Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the seventeenth day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Villeray Metallic Industries Limited\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1948.L.DÉSILETS, 22397 Deputy Attorney General.Ditto (Quebec) Ltd.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date «lu premier mai 1948, changeant le nom de lu compagnie \"James D.Black, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 décembre 1935, en celui de \"Ditto (Queliec) Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1948.L'Assistant-procureur général, 22448 L.DÉSILETS.Ditto (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the 1st day of May, 1948, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"James D.Black, Limited\", incorporated by letters patent dated December 28, 1935, into that of \"Ditto (Quebec) Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General the 1st of May, 1948.L.DÉSILETS, 22448-0 Deputy Attorney General.Action en séparation de corps et de biens Canada, province de Québec, district d'Abi-tibi, Coui Supéiieure, Ne V-1224.Dame Blanche Yvette Robitaille, ménagère, épouse commune en biens de George Odilon Tunnel, demeurant et résidant à Sullivan, district d'Abitibi, demanderesse, vs Georges Odilon Turmel, mineur, demeurant et résidant à Sullivan, district d'Abitibi, défendeur.Une action en séparation de corps et de biens a été instituée contie le défendeur en cette cause le 28 mai, 1948.Val d'Or, Que., ce 3 juin 1948.Le Procureur de la demanderesse, 22412-0 C.C.TASCHEREAU.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL .CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 685 Québec, le 19 mai 1948.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant la désignation et la description des \"Régions Sauvegardées\" établies pour les fins de protection des forêts contre l'incendie.Attendu que pour simplifier l'émission des permis de circulation et faciliter le contrôle de fa circulation sur les terres de la Couronne vacantes ou affermées, comme sur les terrains privés d'une étendue supérieure à 2000 acres, il y a heu d'adopter la désignation suivante plus Action for Separation as to Bed and Board and Property Canada, Province of Quebec, District of Abiti-bi, Superior Court, No.V-1224.Dame Blanche Yvette Robitaille, wife of Georges Odilon Turmel, of Sullivan, district of Abitibi, plaintiff, vs The said Georges Odilon Turmel, miner, residing at Sullivan, district of Abitibi, defendant.An action for separation as to bed, board and property was instituted in this case on the 28th day of May, 1948.Val d'Or, June 3, 1948.C.C.TASCHEREAU, 22412-o Attorney for Plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 685 Quebec, May 19, 1948.Present: The Lieutenant-Governor in Council: Respecting the designation and description of the \"Safeguarded areas\" established for the purpose of the protection of Forests against fire.Whereas to simplify the issue of the travel permits and facilitate the control of traffic on Crown lands, whether vacant or leased, as also on private lots of land of an extent superior to 2000 acres, it is expedient to adopt the following more precise designation indicating the Safe- 1720 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 12 juin 1948, Tome 80, N° 2L précise pour démarquer les \"Régions Sauvegardées\", telles qu'établies par l'arrêté de l'exécutif du 22 mai 1035.Il est oh now k, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre des Terres et Forêts: Que les \"Régions Sauvegardées\" où sont comprises à la fois les (erres de la Couronne vacantes, des forêts all'ennécs et des forêts privées d'une étendue d'au moins 2000 acres soient désormais spécifiquement désignées comme suit: I.UNGAVA : Tout le territoire du nouveau Québec.II.MISTASSINT : Tout le territoire compris entre la limite sud du nouveau Québec et la limite nord des districts électoraux d'Abitibi Ouest, Abitibi Est, de Roberval et de < 'bief ml in ii.et dont les eaux se déversent dans la Haie James; III.COTE-NORD : Le district électoral «le Saguenay.IV.ABITIBI : Les districts électoraux d'Abi-tibi-Oucst et d'Abitibi-Est.V.TÊMISCAMINGUE : Les «listrif the assets of the company rateably among the shareholders in accord* once with their respective rights or in accordance with the directons for distribution given to the company by all the shareholders is hereby authorized.2.Any tWO officers «jr directors of the company arc hereby authorized ami directed for and on behalf and in the name of the company to sign, execute anil deliver, ami affix the seal «>f the company to, all such deeds, agreements, «locuments, instruments and writings and ffice of Return- d'élection, les nominations suivantes: ing-Officer, the persons whjee names follow: District électoral Electoral district\tNom, Prénoms Name, Christian names\tProfession ou occupation Profession or calling\tDomicile Domicile \tArsenault, P.-Daniel (1) Bcaulieu, J.-Kxiiner (2) .\tMareliainl-Merchant.Comptablc-Accountant .Mesureur de bois Timber scaler\tBomt venture.La Mal baie.Montréal.Baie Com\u2014 (1) JSn remplacement de M.Hubert Bourque, démissionnaire.(2) En remplacement «le M.Marc Lacoste, démissionnaire.Québec, le H) juin 1948.En vertu de l'article 19.Le Président général des élections, 2_'tôi>-«> FRANÇOIS DROUIN.J.B.Martin Compagnie, Limites J.B.Martin COMPANY, Limited ('«\u2022pic certifiée du règlement pour augmenter ie nombre «les directeurs Je, Edwin G.Hellyar, secrétaire «le la compagnie \"J.B.Martin Compagnie, limitée \u2014 J.B.Martin Company, Limited\", certifie par les présentes, conformément à l'article 84 «le la Loi «les compagnies de Québec, «pie le suivant est une copie «\u2022onforme et exacte «le la section 2 «le l'article 111 «les règlements «lûment adopté et approuvé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale Convoquée dans le but «le consif directors shall consist of eleven (11) members.Euch director shall be a sharehoulcr owning at least one share of stock absolutely in his own right and not in arrears in respect of any call thereon.The directors shall be elected at the annual meeting of the shareholders, and each director shall be elected t«) serve until the next annual meeting of the share- 1728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, IS juin 19 ah, Tome SO, N° sa aumiehe «les actionnaires et jusqu'à os que son successeur soit élu et qualifié.\" Kn foi de quoi, j'ai signé et apposé le sceau «le ladite compagnie !«\u2022 10 juin 1948.(Sceau) 22458 Le Secrétaire.EDWIN G.HELLYAR holders and until lus successor shall l>e elected and shall «pialify.\" In witni'ss whereof I have hereunto s«*t my hand and have hereunto affixed the seal of said company this 10th dav of Juin-, 1948.(Seal) EDWIN G.IIKLLYAR, 224Ô8-0 Secretary.Chartes -Abandon de Charters \u2014 Surrender of Hatley F ABM Limited Avis est, pai les présentes, donné que \"Hatley Farm Limited\" se propose «le «lemandcr au Pro* cureur général de la province «le Québec la permission d'abandonner sa charte.Daté à Sherbrooke, Québec, ce 31e jour de mai 1948.I*e Secrétaire, 22419-e FoxiiAi.n P.KbbmbTatlob.Hatley Fakm Limited Notice is hereby given that \"Hatley Farm Li-mited\" intends forwith to apply to the Attorney General «>l the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Dated at Sherbrooke, Quebec, this 31st of Mav.1948.Foxham, P.Keene Taylor, 22419-o Secretarv.Hex Investments Inc.AVIS Kn vertu des dispositions «le la Loi des < onipa-gnics He Québec, telle qu'amendée, \"Rex Investments Inc.\" donne avis par les présentes, qu'elle fera application à l'honorable Procureur général de la Province de Québec pour qu'il accepte I'a-bandon «le sa charte et n ordonne son annulation, et fixe une date à compter «le laquelle elle sera dissoute.Montréal, P.Q., le 31 mai, 1948.Ix* Secrétaire, 22426-0 VV.P.CREAGH.Hen Investments Inc.NOTICE Under the provisions ol the Quebec Companies Act, as amended, \"Ilex Investments Inc.*' hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney General of the Province of Quebec for acceptance of the surremler of its chattel and to direct its cancellation and fix a «late upon ami from which it shall be dissolve»!.Montreal, P.Q., Mav 31st, 1948.W.P.CREAGH, 22420-o Secretary.Compagnie autorisée à faire des affaires Company Licensed to do Business Avis est, par les présentes, «lonné que la compagnie \"Maiine Electric Limitc«l\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations «le même nature créées en vertu «les Lois «le la province «le Québec et sujets aux mêmes formalités prescrites par les Lois existantes «le cette Province.L'agent principal de ladite compagnie dans la province de Québec, aux fins «le recevoir les assignations dans toute poursuite ou piocédure intentée contre elle, est M.G.T.R.Campbell, 400 ouest, rue Craig, cité de Montréal.Le bureau piincipal de la corporation, «lans la province de Québec, est établi à 1025 ouest, rue Sherbrooke, «lans ladite cité «le Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du Secrétaire «le la Province, le 8 juin 1948.Le Sous-secrétaire «le la Province, 22427 JEAN BRUCHESI.Notice is hereby given that \"Marine Electric Limited\" has been licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Piovince of Quebec ami subject to the same formalities as arc prescribed by the existing laws of this Province.The chief agent of the said company in the Province of Quebec for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it, is Mi.G.T.R.Campbell, «>f 400 Craig St.West, in the city of Montreal.The principal office of the Corporation in the Province of Quebec is established at 1025 Sherbrooke Street.West, in the said city of Montreal, in the judicial district ol Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary the 8th dav of June 1948.JEAN BRUCHÉSI, 22427-o Under Secretarv of the Province.Départ et nent des Affaires municipales Départi i en t of Municipal Affairs Le soussigné donne avis «pie.tel que demandé The undersigned gives notice that, as requested par une résolution du 5 avril 1948 «lu conseil de by a resolution of April 5, 1948.of the Council QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June l.'tli, huh, Vol.ho, No.2k 1720 lu municipalité de Baudot, comté de Rivière «lu-Loup, «'t conformément aux dispositions de l'art i-ole 180 «lu ('«)«!«¦ municipal, il a aidorisé, «m date du 2 juin 1948, que lei publications «le tous les avis publics, réglementa, résolution! ou ordies de lu dite corporation, said celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.\\a' présent avis est publié «m conformité «le l'article 131 «lu Code municipal.(10 George VI, chapitre 66, section 2).Québec, l«- 2 juin 1948.Ia' Ministre des Affaires municipales, 22399m BONA DÙSSAULT.Le soussigné donne avis que tel que demandé par une résolution du 2-1 mai 1018 du conseil «le la paroisse de St-I)amicn, comté «le Berthier.et conformément aux dispositions «le l'ai tide 130 «lu Code municipal, il a autoiisé, en date «lu 5 juin 1948.que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la- «iite corporation, sauf celles requises «lans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité «le l'article 131 «lu Code municipal.(10 George VI, chapitre .r)5, section 2).Québec, le 6 juin 1948.Le Ministre des Affaires municipales, 22416* BONA DUSSAULT.of the Municipality of Baudot, county «»f Rivière-«lii-Loup, ami in conformity with the provisions «>f article 130 of the Municipal i !ode he bas ordered, under date of June 2.19-18, that publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of tin- said Corporation, save those required in the Quebec Official Gazette, be ma«lc.in futur»', in the French language only.The present notice is publishetl in conformity with article 131 of the Municipal Code (10 George VI, chapter ftft, section 2).Quebec.June 2, 1948.BONA DUSSAULT, 22399 Minister of Municipal Affairs.The undersigned gives notice that as requested by a resolution of Slay 24, 1948, of the Council of the parish of St-Damicn.county of Berthier and in conformity with the provisions of Article 130 of the Municipal Code, be has authorised, Under date of June ft, 1948.that publications of public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, save those required for the Quebec Official Gazette, be in future, in the Franch language only.The present notice is published in conformity with Article 131 of the Municipal Code.(10 Georges VI.chapter ftft, section 2).Quebec .June 6, 1948.BONA DUSSAULT.22410 Minister of Municipal Alfairs.Département de l'Agriculture Avis «'rt par le présent donné qu'une société coopérative agricole a é'té constituée dans le comté «le Champlain, en vertu «le la loi des sociétés coopératives agricoles (S.R.1941, c.120), sous le nom de \"Société Coopérative Agricole Régionale de La Tuque\" et que son principal siège d'affaires est à La TiKpie.Le ministre autorise la formation de cette société.Québec, ce neuvième jour de juin 1948.Le Sous-ministre «le l'Agriculture, 2244 l-o JULES SI MARI).Department of Agriculture Notice is hereby given that a cooperative agricultural association has been formed in the county of Champlain, under the Cooperative Agricultural Associations Act (U.S.1941, c.120) under the, name of \"Société Coopérative Agricole Régionale «le La Tu«pic\" and that its principal place of business is at La Tmpie.The Minister authorizes the formation of th«-said association.Quebec, this ninth day of June, 1948.JULES SIMAR1).22411 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Instruction publique N° 323-48.Québec, le 1er juin 1948.Demande est faite, «le détacher «le la municipalité scolaiie de Saintc-Elavie de Lepage, «lans le comté de Matane, le territoire décrit «lans l'article 9 de 9 George VI, chapitre 91, et d«* l'annexer à- la municipalité scolaire «lu village de Mont-Joli, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.22380-23-2-o J.-P.LABARRE.N° 207-47\\/ ff Québec, le 9 juin 1948.Il a plu a Sou Honneur le Licutetcuit-gouver-ueur en conseil, par arrêté ministériel en date «lu 3 juin 1048.«le détacher «le lu municipalité scolaire de Sainte-André d'Acton, dans le comté «!f lots No.301 and 373 of the official cadastre for St-And ré d'Acton, belonging t«i Mr Pierre Bond, and t«» annex them to the 1730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juin 1948, Tome 80, N° *A nicipulité scolaire .1.range XI, of the township Morin.Quebec.June 1.1948.ANTONIO TALBOT.22121 Minister «>f Roads.Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OF LAURENTIDES Candidats pour l'admission à l'etitdk du dhoit \u2014 Candidates fou the admission' to thr htuuy ok law Examens de juillet WJ,8 \u2014 Examinations of July, 1948 Noms\tPrénoms\t\tRt'sidences\tCollèges \u2014\t\u2014\tarc\t\u2014\t\u2014 Names\tSurnames\t\tRésidences\tColleges Ollgas\t\t19 22\tJoliette.\tSéminaire de Joliette.Collège Séraphique (Trois-Rivières) Séminaire de Joliette.Robillar«l .\tRoland.\t\tSt-Cuthbert.\t \t\t\t\t Joliette, le 27 mai 1!)4S \u2014 Joliette.May 27, 1948.Le Secrétaire du Barreau des Laurentides.MAURICE MAJEAU, 22389-23-2-o Secretary of the Bar of Laurentides. 1732 GAZETTE OFFICIE LU-: DE Ql'F.HEC, Quebec, li juin i9ah.Time HO, N° *k BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OF LAURENTIDES Candidat pour i.'admihhion à i.a m ATI QUI DC droit\u2014Candidate fou tiif.admission to the phacti«b , of law Examens de juillet ll)J,8 -\u2014 Examinations of July, W48 Norn Name Dugas.Jacques _!_ Prénom Surname Age Résidence Residence 21 Joliette.Joliette, le 27 mai I04H Joliette, May 27.1948.22390-23-2-0 Le Secrétaire du Barreau des Laurentides, MAURICE MAJEAU.Secretarv of the Bar of Laurentides.BARREAU DE SAINT-FRANÇOIS \u2014 BAR OF SAINT FRANCIS Candidat pour i.\"admission a l'étude du droit \u2014 Candidate for the admission to the study of law Examens de juillet 11)18 \u2014 Examinations of July, li)J,8 Nom\t\tPrénom\tAge\tRésidence\tCollège Name\t\tSurname\t\tResidence\tCollege Gervais .\t\tI'aul\t22\tSherbrooke .\tSt Patrick Academy, Séminaire 8t-Charles Borromée et Collège Loyola.\t\t\t\t\t Sherbrooke, le 27 mai 1948 Sherbrooke, May 27, 1948.Le Secrétaire du Barreau de Saint-François, JEAN-LOUIS PÉLOQUIN.22391-23-2-0 Secretary of the Bar of Saint Francis.BARREAU DE SAINT-FRANÇOIS \u2014 BAR OF SAINT FRANCIS Candidats pour l'admission à la pratique du droit \u2014 Candidates for the admission to the praoticii or law Examens de juillet 11(48 \u2014 Examinations of July, 11)^8 Noms\tPrénoms\t\tRésidences \u2014 ,\t\u2014\tAge\t\u2014 Names\tSurnames\t\tResidences \t\t25 33\tChnrtierville.Sherbrooke.Olivier.\t\t\t Sherbrooke, le 29 mai 1948 Sherbrooke, May 29, 1948.Le Secrétaire du Barreau de Saint-François, JEAN-LOUIS PÉLOQUIN, 22392-23-2-0 Se.-retary of the Bar of Saint Francis.BARREAU D'ARTIIABASKA \u2014 BAR OF ARTHABASKA Candidats pou h l'admission à la pratique du droit\u2014 Candidates for the admission to tub prautici of law noiiis\tPrénoms\t\tRésidence\t\tCollèges\t \u2014\t\u2014\tAge\t\u2014\t\t\u2014\t Names\tSurnames\t\tResidence\t\t( 'olleges\t \t\t27 23\t\t\tNicolet.Québec.\t Marcotte.\tClaude .\t\tThetford Mines .\t\t\t Vicioriaviile.le 8 juin 1918 \\ ictoriaville, June 8.1«J48.22459-24-2-0 Le Secrétaire du Barreau d'Arthabaaka, LAURENT TROTTIKR, Secretary of the Bar of Arthabaska. QUEBEC OFFICIAL BABETTE, Quebec, June uth, was, Vol.so.So.\", 1788 BARREAU DEB tkois-kiviekks BAB OF TROIS-RIVIERES Candidats i'och i.'admihhion à l'étude du droit; Candidates i ok tuf.admission to the study of law Examina de juillet t$4§ \u2014 Examinations of July, f§M Noms\tPrénoms\t\tRésidence\t( 'ol leges \t\tan\t\u2014\t Name-\tSurnames\t\tR wiflii ft\t< SollefjN BoUiw\tRood ¦ ¦\t1!) 22 IS\tSt-Rap bail da Bel 1er liasse.( !raiiec.25\tQuébec.25\tQuébec.31\tQuébec.Le Secrétaire du Barreau de Québec, ROGER THIBAUDEAU, Secretary of the Bar of Quebec.Nomination Appointment Il a plû à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, dé l'avis et du consentement du Conseil exécutif) et J ar commissions, de faire lus nominations suivantes: Qluébee, 13 mai 1948, MM.Louis-H.Duhamel, oomptable-évalua-teur, 4503 nie Bordeaux, Montréal, «-t Marcel Pigeon, commis, 41 Cbemin 8te-Foy, app.9, Québec: juges de paix avec juridiction sur toute la province de Québec; Joacnim Bachand, opto-métriste, S9-B, rue King Ouest, Sherbrooke: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de St-Krancois; Adolphe Ja mieux, inspecteur.Commission du salaire minimum, 99ô rue Clierrier, Delphi* Pépin, gérant, 70S rue Marin.Alexander A.Kelen.agent de voyages et représentant de différentes compagnies de transport maritimes, 3688 avenue du l'arc, AugUSte-Nor-bert Campeau, sécréta ire-archiviste de l'Ordre des Forestiers de la Cour Sl-IIcnri, No 641, et.l'uni Deguire, assistant-greffier, Cour du recorder de Montreal.2-6 rue DeCastelnau.tous cinq de Montréal, l'aul Poirier, gérant, 3545 rue Evelyne.Paul-Emile Lord, employé à la Northern Electric Company, 3238 avenue Verdun, Aimé Barre, comptable, 2797 rue Ethel, Unis trois de Verdun: juges de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Montréal: \u2014 Les juges de paix nommés dans le présent paragraphe le sont aux fins de recevoir le serment seulement, conformément aux dispositions de l'article 358 de lu Loi «les tribunaux judiciaires (S.R.Q., 15141, chapitre 16).Québec, 19 mai 1948.MM.J.-Alexandre Cant in, de Ste-Catherine.Cté l'ortneuf, chef mesureur pour la Dounacona Paper Co.Ltd.: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Québec; lt.Ciiroux, assistant-surintendant de l'Industrielle Compagnie d'assurance sur la vie, «le Tnetford-Mines: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire d'Arthabaska; Rodolphe Paterson, maître «le poste, «le Val «l'Or, et Peter Morrisson.agent His Honour the Lieutenant-Governor lias been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, to make the following appointments: i Quebec May 13, 1048.Messrs.Louis II.Duhamel, accountant-appraiser, 4502 Bordeaux Street, Montreal, ami Marcel Pigeon, derk, 41 Ste-Foy Road, Apt.0, Quebec* to !>«\u2022 Justices of the Peace wit.li jurisdiction over I be whole Province of Quebec; Joachim Bachand, optometrist, 80-B King Street West, Sherbrooke: to be a Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial district of St.Francis; Adolphe Lemieux, inspector, Minimum Wage Commission, 996 Clierrier Street, Delpbis Pépin, manager, 768 Marin Street.Alexander A.Kelen.travel agent and representative for several maritime transport companies, 3533 Park Avenue, Auguste Norbert Campeau, recording secretarv of \"l'Ordre «les Forestiers de la Cour St- Hcnri No 641\", and Paul Deguire.deputy Clerk.Recorder's Court of Montreal 2-t> DeCastelnau Street, all five of Montreal.Paul Poirier, manager.3545 Evelyne Street, l'aul Emile Lord, employee of the Northern Electric Company, 3238 Verdun Avenue.Aimé Barre, accountant, 3797 Ethel Street, all three of Verdun: to be Justices of tli*\" Peace with jurisdiction ovei the judicial district, of Montreal: \u2014The Justices of the peace named in the present paragraph are appointed as such for the purpose of administering the oath only, pursuant to the provisions of section 368 of the Courts of Justice Act (R.S.Q.1941.chapter 15).Quebec, May 19, I94S.Messrs.J.Alexandre Cantin, of Ste-Catherine, county of l'ortneuf.chief scaler for the Donna-cona Paper Co.Ltd.: to be a Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial f Our Province of Quebec ami to all to whom it may concern.gueetin«i.V\\7\"IIEREAS We have thought fit, by and VV with the advice of the Executive Council «>f tin- Province of Quebec, to «lissolve the present legislature of the sai«l Province; Theuekoke, We whom these presents shall come or whom the same may concern, Gheetin«;.WHEREAS We are desirous ami have decided to meet as soon as possible the People of the Province of Quebec and to have their advice, expressed in Parliament; Therefore, by and with the advice «)f the Executive Council of the Province of Quebec, We do hereby convene a new legislature of the Province for the twenty-ninth of September next, and ort of every professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.This Committee has the right to exact sworn reports every time it shall deem it advisable.The report together with levies shall be sent to the Parity Committee on or before the Wednesday following the date of the period for which the said report is requirable.3.Financial report According to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 3,1 st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry, for the period ending March 1st 1949.Joint Committee of the Sheet Metal, Fabricating Industry 655, New Birks Building, Montreal.Estimate of receipts and disbursements required by the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry for the administration of Decree number 660.Period from June 1st, 1948 to March 1st, 1949.Receipts: Levies from professional employers.$4,500.00 Levies from employees.4,500.00 $9,000.00 Disbursements: Building Materials Joint Committee (Services at $500.00 per month) .$4,500.00 Auditor.175.00 Secretarv-Treasurer.315.00 Legal Expenses.960.00 Printing and Stationery.345.00 Traveling Expenses.600 00 Unforeseen expenses and sundries.180.00 Attendance fees.1,215.00 Office expenses and miscellaneous.710.00 $9,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 12, 1948.22443-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941), chapter 163 and amendments), that the Eastern Townships Retailers' Joint Committee established under decree number 2331, of June 17, 1940, and amendments, and entrusted with the admi- 1750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 12 juin 1918, Tome 80, N° 21 juin 1940, et amendements, et chargé de surveiller l'application des décrets numéros 3510, du 21 septembre 1944et 2861,du 17 juillet 1946, a été autorise par règlement approuvé pur l'arrêté en conseil numéro M 2 du 3 juin 1948, section \"A\", a prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis auxdits décrets, suivant la méthode et le taux ci-après : 1.Cotisation La période tic cotisation s'étend du 1er juin 1948 au 1er juin 1949.Toutefois, si l'un des décrets ci-haut mentionnés expire ou est abrogé avant le 1er juin 1949, les dispositions du présent règlement cesseront de s'appliquer aux employeurs professionnels, artisans et salariés assujettis audit décret.Cette cotisation s'exerce comine ci-dessous mentionné : a) Les employeurs professionnels régis par lesdits décrets doivent verser au comité paritaire une somme équivalente de y& 'h' 1% (U>s salaires fixes, boni et pourcentage payés à leurs salariés assujettis auxdits décrets.b) Les artisans (les propriétaires d'établissements qui n'ont pas d'employés ou salariés) régis par lesdits décrets, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à de 1% du salaire établi poux le salarié: i.Le moins rémunéré, soit 18.06 par semaine dans les territoires régis par les décrets numéro 2331 et 3516.ii) Moyennement rémunéré, soit $20.00 par semaine dans le territoire régi par le décret numéro 2861.c) Les salariés assujettis auxdits décrets doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à x/i de 1% de leurs salaires, boni et pourcentages.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception'de ces cotisations, le comité paritaire peut mettre à la disposition des employeurs professionnels régis par lesdits décrets des formules de rapport sur lesquelles doivent être inscrits les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à leur emploi, sa qualification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé ainsi que les sommes qui doivent être versées au comité paritaire.L'employeur professionnel doit percevoir à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent au comité paritaire et les remettre lui-même audit comité.Le comité paritaire exige que le rapport de l'employeur professionnel, dûment signé et accompagné des cotisations, de même que les cotisations des artisans ou des salariés, suivant le cas, lui soient remis à son siège social,, 29 rue Gordon, Sherbrooke, Que., dans les dix premiers jours de chaque mois.Le comité paritaire a le droit et le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail, aux dates fixes suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.nistration of decrees number 3516 of September 21, 1944 and 2861 of July 17, 1946 has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 812 of June 3, 1948, part\"A\" to levy assessments u\\nm the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decrees according to the following method and rate.1.Assessments The period of assessments extends from June 1 1948, to June 1, 1949.However, should one of the decrees above mentioned expire or be repealed before June 1, 1949, the provisions of the present by-law shall cease to apply to the professional employers, artisans and employees governed by the said decree.'Such assessments shall be applied as follows: a) The professional employers governed by the said decrees shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to x/i of 1% of the fixed wages and of the bonuses and percentages paid to their employees governed by the said decrees.6) The artisans (owners of establishments having no employees) governed by the said decrees shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to \\ ternie \"ai.le-
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.