Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 juillet 1948, samedi 17 (no 29)
[" Tome 80, N° 29 2023 Vol.80, No.29 4\t\t\u2022!\u2022 _\t\t1 *\t\t \t\t (Drapeau de la province de Québec, adopté par arrêté en conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flug of the Province ef Quebec, adopted by Order in Council Number 72, bearing date January 21st, 1948.) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT 01 LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PU BU SHED BY THE PROVINCIAL GOVERN MENT) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 17 juillet 1948 PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, July 17th, 1948 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le taiif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent êtie publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement .payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Adress all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter 2024 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 191,8, Tome 80, N° 29 délai pour lu réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour féijé.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publié* dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typogiaphiquc se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, clc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 2GG lignes par page, |>our les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.1$.\u2014 Les chiffre* places au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chitfie réfèie à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre tradetion.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Hutes, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version.(14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: Si.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.21991 \u20141-52 RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Québec, 27 juin 1940.Government House.Quebec, June 27th, 1940.21991 \u2014 1-52 Lettres patentes Letters Patent Armor Automotive Distributors Inc.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juin 1948, constituant en corporation : Morris Goldberg, Arthur Hornstein, marchands, Nathaniel Leonard Rappaport, avocat, et Sydney Phillips, commis, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général de toutes sortes d'automobile, véhicules-moteurs, moteurs, engins, machines carburateurs, accessoires, pièces; appareils électriques de toute description, appareils de maison, ferronnerie, machinerie et outillage poui la construction, ainsi que les commodités incidentes et connexes sous le nom de \"Armor Automotive Distribu-tors Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le nombre de ses actionnaires sera limité à 20 Armor Automotive Distributors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June 1948, incorporating: Morris Goldberg, Arthur Hornstcin, merchants, Nathaniel Leonard Rappaport, advocate, and Sydney Phillips, clerk, all of the City of Montreal, judicial district of Monti cal, for the following purposes: To manufacture, and generally deal in all kinds of automobiles, motor vehicles, motors, engines, machines, carburators, accessories, parts; electrical appliances of every description, household appliances, hardware, building machinery and equipment, as well as incidental and allied commodities, under the name of \"Armor Automotive Distributors Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each, and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The number of its shareholders shall be limited to 20. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th, 19*8, Vol.80, No.29 202» Le siège social de la compagnie sefa à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1948.L'Assistant-procuieur général, L.DÉSILETS.Commodore Hotel & Yucht (lui» Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois juin 1948, constituant en corporation: Lucien Tessier, vendeur, Alfred Hurtu-bise, agent d'assurance, tous deux de la cité de Montréal, et Jean-Paul Dubreuil, agent, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de tenanciers et propriétaires d'hôtels, auberges, maisons de pension, restaurants, cafés, salles et lieux de rafraîchissements, conjointement avec le commerce d'organisateurs, aménageurs et administrateurs de cercles ou clubs nautiques dans la province de Québec, sous le nom de \"Commodore Hotel & Yacht Club Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Corporation de Placement Adunac Adanac Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois juin 1948, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, Gaston Dubreuil, Jean-Paul Cardinal, avocats, Ghislaine Gagné, sténographe, fille majeure, et Marcelle L.Frizzle, secrétaire, épouse judiciairement séparée de corps et de biens de Arnold L.Frizzle, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les fonctions d'une compagnie de placements et faire toutes choses nécessaires en rapport avec les dites fonctions; Sujet à la loi des assurances de Québec et aux règlements faits sous son empire agir comme courtiers en assurance et comme agents et courtiers pour le placement, let- prêts, les paiements, la transmission et l'encaissement de deniers, sous le nom de \"Corporation de Placement' Adanac\" \u2014 \"Adanac Investment Corporation\", avec un capital de $110,000, divisé en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune et 10,000 actions communes d'une valeur de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1948.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Devon Investments Ltd.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf juin 1948, constituant en corporation: ^William Patrick Creagh, The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of June, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Commodore Hotel & Yacht Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of June, 1948, incorporating: Lucien Tessier, salesman, Alfred Hurtuhise, insurance agent, both of the city of Morrtreal.and Jearr Paul Dubreuil, agent, of the city of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To earjy on business as hotel, inn and boarding house keepers and owners; keepers and* owners of restaurants, cafés, refreshment rooms and premises, jointly with the business of organizers, furnishers and mauagers of nautical clubs or circles irt the Province of Quebec, under the name of \"Commodore Hotel & Yacht Club Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of June, 1948.L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Corporal ion fie Placement \\erator (preliminary finish).Single end tenon machine operator.Rod turning machine operator.Hand buzz planer operator.Clamp carrier operator.Double saw operator (cuts to lenght).Double trim saw operator (cuts to lenght and width).Automatic jointer operator.Taping machine and splicer operator.Double chucking machine operator.Decorator and transferer.Mirror fixer.Crater and packer.Operations and employees of Class III.Automatic buzz planer operator.Rough planer operator.Sub assemblies with clamps.Brush stain-filler or any other material.Wipe stain-filler or any other material.Sealer (sanding sealer).Dip-stain filler, sealer, varnish, etc. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th, 19 tf.Vol.80 No.29 2041 Opérateur, sableuses diverses (excepté courroie).Appareiller punneuux de bois.Préposé au pilugc du bois pour les séchoirs.Assembleur de chaises ou parties de chuises (sans l'aide de serre-joints).Inspecter et réparer feuilles de \"Veneer\".Assembleur de tiroirs (sans l'aide de serre-joints).Opérateur de \"Chuck\" simple.Opérateur de perceuse simple (1 et 2 mèches).Opération! et salariés de la classe IV Toutes les opérations qui n'apparaissent pas dans les classes I, II, et III.Dispositions spéciales 1.Avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, tout salarié a droit au taux de .salaire prévu pour ce groupes lorsqu'il a atteint l'âge de 19 ans, son taux minimum est c.dui prévu pour le premier trimestre à la classe IV et le taux est augmenté, tel qu'indiqué, pour le deuxième trimestre et ainsi de suite.2.Aucun salarié n'a droit au taux minimum horaire d'une opération elassifiée, à moins d'avoir une année d'expérience dans l'industrie, pas nécessairement dans le même établissement industriel, tout en tenant compte de la restriction prévue au paragraphe précédent pour les salariés de moins de 19 ans.3.Lorsque les conditions ci-haut mentionnées ont été observées,tout employeur doit payer à tout salarié exécutant une opération elassifiée, au moins le taux prévu pour lu dite opération.4.Si un salarié exécute plusieurs opérations, il doit recevoir comme taux régulier, au moins le taux le plus élevé prévu dans la classification cj- desaua.5.L'expérience acquise dans l'industrie, au moment de la mise en vigueur du présent décret, compte pour l'application immédiate des taux plus haut mentionnés.IV.Les clauses ci-dessus ne peuvent en aucun cas permettre la réduction des taux de salaires actuellement payés, soit à l'heure, soit à la pièce.V.Semaine de travail et temps supplémentaire Zones I, Il et III: a) La semaine régulière de travail dans les zones I, II et III est de cinquante (50) heures, soit neuf (9) heures par jour, du lundi au vendredi inclusivement, et cinq (5) heures, le samedi.b) Le travail, durant la semaine régulière ci-haut décrite, doit être exécuté entre sept (7) heures du matin et six (0) heures du soir, du lundi au vendredi inclusivement, et entre sept (7) heures du matin et midi le samedi.c) De la première période de paye de juin à la première période de paye d'octobre, chaque année, il n'y a pas de travail le samedi matin.Dans ce cas, la journée régulière de travail ne doit pas excéder dix (10) heures et le travail est exécuté( du lundi au vendredi inclusivement, entre sept' (7) heures du matin et six (G) heures du soir, à moins d'entente à ce contraire, pour conserver la semaine régulière indiquée au premier paragraphe du présent article.Tout travail exécuté en dehors des heures régulières ci-haut prévues doit être rémunéré au taux de salaire et demi.d) La semaine normale de travail des préposés à l'expédition, à l'entretien et à la réparation, est de cinquante (50) heures et la journée régulière de travail ne doit pas excéder dix (10) heures, sans Operator of miscellaneous sanding machines except belt.W ( m (1 panol mutching.Piling lumber for dry kiln.Chair or chuir purts assembler (no clamp).Inspecting and repairing veneer.Drawer assembler (no clamp).Single chuck operator.Single-borer operator (1 and 2 spindles).Operations and employees of Class IV All operations not appearing in classes 1, II and Hi.Special provisions Before reaching the age of 19, any employee is entitled to the rate of wages provided for this group ; and when the employee has reached the age of 19, his minimum rate is that which is provided for the first three (3) months iu Class IN', and such rate shall l>e increased, as indicated, for the second three (3) months and so on.2.No employee is entitled to the minimum hourly rate fixed for a classified operation, unless he has a year's experience in the industry, not necessarily in the same industrial establishment, due allowance being made for the restriction I rovided for iu the p ecedeing subsection respecting employees of less than 19 years of age.When the above conditions have Been fulfilled, every employer shall pay to every employee performing a elassiiied operation, at least the rate provided for such operation.4.If an employee performs several operations, he shall receive as his regular rate, at least the highest rate provided for in the above classification.5.The expe: ience acquired in the industry, at the time when the present decree becomes effective, is to be taken into account for the immediate application of the above mentioned rates.IV.The above mentioned clauses cannot, in any event, permit the reduction of the wage rates actually paid, either by the hour or for piece work.V.Regular working week and overtime.Zones I.II and III.a) The regular working week in Zones I, U and III consists of fifty (50) hours, that is, nine (9) hours per day from Monday to Friday inclusively, and five (5) hours on Saturday.6) During the regular working week described above, work shall be performed between 7.00 a.m.and 6.00 a.m., from Monday to Friday inclusively, and between 7.00 a.m.and 12 o'clock noon on Saturday.c) E -cry year, from the first pay period of June to the first pay period of October there shall be no work on Saturday morning.In such case, in order to maintain the regular working week indicated in the first subsection of the present section, the regular working day shall not exceed ten (10) hours and the work shall be performed from Monday to Friday inclusively, between 7.00 a.m.and 6.00 p.m., unless an agreement to the contrary has been made.Any work performed outside the regular hours provided for here-inabove shall be remunerated at the rate of time and one half.d) The regular work week for employees committed to shipping, maintenance and repair .\u2022\u2022hall consist of fifty (50)hours and the regular working day shall not exceed ten (10) hours, 2042 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 1948, Tome 80, N° 29 restriction quant à l'heure du début et de la fin du travail.Tout travail exécuté après cinquante (50) heures doit être rémunéré au taux de salaire et demi.e) La semaine normale des chauffeurs de bouilloires et des mécaniciens de machines fixes, est de cinquante-six (56) heures, sans autre restriction.Tout travail exécuté après cinquante-six (56) heures doit être rémunéré au taux de salaire et demi.f) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux gardiens, aux chauffeurs de camions et aides, aux préposés aux camions, aux conducteurs de voitures à traction animale et aides.g) Nonobstant ce qui précède, l'employeur a le droit d'employer une équipe régulière de nuit, entre sept (7) heures p.m.et six (6) heures a.m., sauf le samedi et le dimanche.La règle du travail supplémentaire, à raison de salaire et demi, s'applique aux travailleurs de l'équipe régulière de nuit, en dehors des heures ci-haut indiquées.h) Sauf entrente au contraire, si une équipe régulière travaille moins de cinquante (50) heures, les salariés concernés reçoivent leur taux régulier, à temps simple, jusqu'à concurrence de cinquante (50) heures par semaine, après quoi la règle du temps supplémentaire à raison de sais ire et demi s'applique.VI.Dimanches et jours de fêtes: a) Zone I: Tout travail exécuté durant l'un des jours ci-dessous mentionnés doit être rémunéré au taux de salaire double: tous les dimanches; le 1er de l'An; le Vendredi Saint; ' la Saint-Jean-Baptiste; la Confédération; la Fête du Travail; la Toussaint et le jour de Noël.b) Zones II et III.Tout travail exécuté durant l'un des jours ci-dessous mentionnés doit être rémunéré au taux de salaire et demi: tous les dimanches; le Premier de l'An; l'Epiphanie; le Vendredi Saint; l'Ascension; la Toussaint; l'Immaculée Conception et le Jour de Noel.La même règle s'applique aux jours de la Saint-Jean-Baptiste, de la Confédération et de la Fête du Travail, en ce qui concerne les manufacturiers de meubles qui se trouvent dans une localité où ces jours sont déclarés fêtes publiques.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chauffeurs de bouilloires, mécaniciens de machines fixes, gardiens, chauffeurs de camions et aides ou préposés aux camions.VH.Aucun employeur n'a le droit de punir ou de menacer de punir, tel que par congédiement ou suspension, directement ou indirectement, un ouvrier qui s'absente du lieu de travail un dimanche ou un jour de fête religieuse.VIII.Minimum de paie.Tout salarié requis de se présenter à l'usine pour son travail doit recevoir une rémunération minimum équivalente à trois (3) heures de travail.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un arrêt des opérations de l'usine et d'un département, dans tous les cas de force majeure.IX.Paiement du salaire.Le montant total de la paie, le nombre d'heures de travail, le temps supplémentaire et le taux horaire doivent être inscrits sur l'enveloppe de paie.X.Vacances payées.Tout salarié assujetti au présent décret a droit à des vacances payées conformément aux dispositions de l'Ordonnance N°3de la Commission du Salaire Minimum de la Province de Québec.XI.Lors de la ratification de la présente convention, le comité paritaire existant, formé pour surveiller l'application du décret antérieur dans without restriction as to the hour at which work starts and finishes.Any work performed in excess of fifty (50) hours shall be remunerated at the rate of time and a half.e) The regular working week for firemen and stationary enginemen shall consist of fifty-six (56) hours, without any other restriction.Any work performed in excess of fifty-six (56) hours shall be remunerated at the rate of time and a half./) The foregoing provisions do not apply to watchmen, truck-drivers and their helpers, truckmen (préposés aux camions) nor to horse-drawn vehicle drivers and their helpers.g) Notwithstanding the foregoing, the employer has the right to employ a regular night shift, between seven (7) p.m.and six (6) a.m., except on Saturday and Sunday.The clause for overtime, at the rate of time and a half, applies to the workers of the regular night shift, for the work they perform outside the regular hours indicated hereinavove.h) Unless an agreement to the contrary be made if a regular shift works less than fifty (50) hours, the workers involved shall receive their regular rate, regular straight time, up to fifty (50) hours per week, after which the clause for overtime at the rate of time and a half shall apply.- VI.Sundays and Holiday a) Zone I: Any work performed during any one of the hereinafter mentioned holidays shall be paid at the rate of double time; Sundays, New Year's Day, Good Friday, St.John the Baptist Day, Dominion Day, Labour Day, All Saints' Day and Christmas Day.b) Zones II and III.Any work performed during any of the hereinafter mentioned holidays shall be paid at the rate of time and one half Sundays, New Year's Day, Epiphany Day.Good Friday, Ascension Day, All Saint's Day Immaculate Conception Day, Christmas Day.This same ruling applies to St.John the Baptist Day, Dominion Day and Labour Day in respect to furniture manufacturers located in districts where they are declared public holidays.The provisions of this section do not apply to boiler firemen, stationary enginemen, watchmen, truck drivers and helpers on trucks.VII.No employer has the right to punish or threaten to punish, such as by dismissal or suspension, directly or indirectly, a worker not going to work on a Sunday or a religious feast of obligation.VLÏI.Minimum pay.Any employee requested to report for work shall receive a minimum amount equivalent to three (3) hours.' pay.The provisions of this section do not apply in the case the suspension of operations in a plant or in any department due to circumstances beyond control.LX.Payment of wages.The total amount of the salary, the number of hours worked, overtime and the hourly rate are to be shown on the pay envelope.X.I acation with pay.Every employee subject to the present decree is entitled to vacations with pay in conformity with the provisions of Ordinance No.3 of the Minimum Wage Commission of the Province of Quebec.XI.On the ratification of the present agreement, the existing Parity Committee organized to carry out the previous decree, in the terri- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th, 1948, Vol.80, No.29 2043 la juridiction territoriale déterminée par le présent décret, demeure en fonction et surveille la mise à exécution du présent décret jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé.Ce nouveau comité succède à l'ancien et est investi de tous les actifs dudit comité; il assume également toutes les dettes de l'ancien comité, en vertu dudit décret antérieur.XII.Le présent décret abroge le décret numéro 639 du 21 février 1946 et ses amendements.XIII.Durée du décret.Le présent décret demeure en vigueur pendant une période d'un an, à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Il se renouvelle de plein droit d'année en année par la sdite, à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre des parties par un avis écrit signifié à l'autre partie dans un délai qui ne doit pas être plus de soixante (60) jours ni moins de trente (30) jours avant l'expiration du terme dudit décret.Tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.XIV.Les dispositions de l'article I (Juridiction territoriale), relatives à la modification du zonage par rapport au décret numéro 639 du 21 février 1946 et ses amendements, n'entreront en vigueur que dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de .publication du présent décret dans la Gazette officielle de Québec.Dans l'intervalle, la juridiction territoriale telle que décrite dans ledit décret numéro 639 et ses amendements, est maintenue.A.MORISSET, 22677-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL .EXÉCUTIF Numéro 926 Québec, le 30 juin 1948.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Concernant la Société des Artisans, l'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport et la \"Loi pour améliorer les conditions de l'habitation\".Attendu que par arrêté ministériel numéro 717, ratifié le vingt-sept mai 1948, diverses compagnies d'assurances, de fiducie ou de prêts ont été autorisées à consentir des prêts d'habitation tels que prévus à la \"Loi pour améliorer les conditions de l'habitation\", 12, George VI, chapitre 6; Attendu que la Société des Artisans et l'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport n'avaient pas encore inscrit leur demande officielle lors de la présentation de ce dernier arrêté ministériel; Attendu qu'il est expédient que les dites compagnies soient autorisées à concourir à la \"Loi pour améliorer les conditions de l'habitation\"; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que la Société des Artisans et l'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport soient autorisées à consentir des prêts d'habitation prévus à la \"Loi pour améliorer les conditions de l'habitation\", 12, George VI, chapitre 6.A.MORISSET, 22660-o Greffier du Conseil Exécutif.torial jurisdiction contemplated by the present decree, shall remain in office and supervise the carrying out of the present decree until a new committee be formed.This new committee supersedes the old one and is vested with all the said committer's assets and rights; it likewise assumes all the liabilities of the former committee, under the said previous decree.XII.The present decree repeals the decree number 639 of February 21 \\ 1946, and all its amendments.XIII.Duration of the decree.The present decree remains in force for a period of one year from the date of its publication in the Quebec Official Gazette.It then revews itself automatically from year to year, unless it be denounced by either of the parties by a writen notice sent to the other party within a delay which shall neither be more than sixty (60) days nor less than thirty (30) days before the expiration of the term of the said decree.Such a notice shall also be sent to the Minister of Labour.XIV.The provisions of section I (Territorial jurisdiction), containing changes in zones with respect to decree number 639 of February 21, 1946, and its amendments, shall come into force only four (4) months after the publication of the present decree in the Quebec Official Gazette.In the meantime the territorial jurisdiction, as described in the said decree number 639 and its amendments, shall be maintained.A.MORISSET, 22677-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 926 Quebec, June 30,1948.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning the \"Société des Artisans, l'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport\" and the \"Act to improve Housing Conditions.\" Whereas by Order in Council number 717 ratified on the twenty-seventh of May, 1948, several insurance, trust or loan companies have been authorized to make housing loans as provided by the \"Act to improve Housing Conditions\", 12 George VI, chapter 6; Whereas the \" Société des Artisans\" and \"l'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport\" had not yet filed their official request, at the time of the presentation of this said Order in Council; Whereas it is expedient that the said companies be authorized to cooperate with the \"Act to improve Housing Conditions\"; It is ordered therefore, upon the recommendation of the Honourable the Prime Minister: That the \" Société des Artisans and l'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport\" be authorized to make housing loans as provided by the \"Act to improve Housing Conditions\", 12 George VI, chapter 6.A.MORISSET, 22660-o Clerk of the Executive Council. 2044 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 17 juillet 19tf, Tome 80, N° 29 Actions en séparation de biens Dame Orner Bois vert, épouse de Léo O'Mal-ley, cultivateur, du canton de M agog, district de St-François, a formé contre son mari, une demande en séparation de biens.Magog, ce 12 juillet 1948.Le Procureur de la demanderesse, 22661-o WES FOREST.Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure N° 263,162.Dame Jeannette Parenteau, épouse commune en biens de (îé.ard Lamy, de Montréal, demanderesse, vs Ledit (îérard Lamy, de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée contre le défendeur lundi, le 28 juin 1948.Montréal, le 5 juillet 1948.Lta Procureurs de la demanderesse, 22662-o Bertrand Grégoire & Dansereau.Province de Québec.District de Québec, N° 54292.Cour Supérieure.Marie-Louise Musse, épouse commune en biens de Jean-Charles Couturier, de la cité de Québec, demanderesse, vs Jean-Charles Couturier, commerçant, du même lieu, défendeur.Ial demanderesse a intenté au défendeur une action en séparation de biens, le 7 juillet 1948.Québec, 12 juillet 1948.Les Procureurs de la demanderesse, 22676-0 GUÊRARD et PELLAND.Avis divers Actions for Separation as to Property Dame Orner Boisvert, wife of Léo O'Malley, farmer, of the township of Magog, district of St.Francis, has instituted an action for separation as to property against her husband.Magog, this 12th day of July, 1948.YVES FOREST, 2266 l-o Attorney for plaintiff.Province of Quebec, District of Montreal.Superior Court, No.263,162.Dame Jeannette Parenteau, wife common as to property of (ié-rard Lamy, of Montreal, plaintiff; vs the said (îérard Lamy, of Montreal, defendant.An action for separation as to property was instituted in fchji caase against the defendant on Monday the 28th dav of June, 194S.Montreal, July 5, 194S.Bertrand, Grégoire & Dansereau, 22662-o Attorneys for plaintiff.Province of Quebec.District of Quebec, No.54292.Superior Court.Marie-Louise Masse, wife common as to property of Jean-( diaries Couturier, of the City en Quebec, Plaintiff, vs Jean-Charles Couturier, tradesman, of said City, Defendant.An action in separation as to property was instituted by Plaintiff against Defendant\", on July 7th, 1948.Quebec, Julv* 12th.1948.GUÉRARD and PELLAND, 22676-o Attorneys for Plaintiff.Miscellaneous Notices AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que le changement de nom de \"La Fraternité Nationale Catholique des Employés de Transport de Québec Inc.\" en celui de \"La Fraternité Nationale Catholique du Transport de Québec Inc.\" a été autorisé par l'honorable Secrétaire de la Province le 17 juin 1948, et ce conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q., 1941, chapitre 162, telles que modifiées par 10 George VI, chapitre 20, article 3.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 18 juin 1948.Le Sous-secrétaire de la Province 22663-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat National Catholique du Textile du Cap-de-la-Madeleine Inc.(Mason Spinning-Laurentian Silk)\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 23 juin 1948.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières- Le Sous-secrétaire de la Province, 22664-o JEAN BRUCHÊSI.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the change of name of \"La Fraternité Nationale Catholique .des Employés de Transport de Québec Inc.\", into that of \"La Fraternité Nationale Catholique du Transport, de Québec Inc.\" has been authorized by the Honourable the Provincial Secretary on the 17th of June, 1948, and such in conformity with the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as amended by 10 George VI, chapter 20, section 3.(riven at the office of the Provincial Secretary, this eighteenth day of June, 1948.JEAN BRUCHESI, 22063-o Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat National Catholique du Textile du Cap-de-la-Madelcine Inc.\" (Mason Spinning-Laurentian Silk)\" for the study, defence and promotion of the economic, social and mora) interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June 23, 1948.The principal place of business of the said professional syndicate is at Trbis-Rivières, judicial district of Tiois-Rivières.JEAN BRUCHÊSI, 22664-o Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th, 1948, Vol.80, No.29 2045 Les Utilités Domestiques, Limitée Domestic Utilities, Limited Règlement N° 5 (Concernant l'augmentation du nombre de directeurs) \"Les Utilités Domestiques, Limitée \u2014 Domestic Utilities, Limited\" décrète ce qui suit: A compter de ce jour, le nombre de ses directeurs qui est actuellement de trois sera augmenté à cinq.Fait et signé à Québec, ce huitième jour d'avril 1948.Adoptée à l'unanimité.Le Président.GEORGES-A.LANG LOIS.I^e Secrétaire, 89671* GABRIEL MERCIER.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une swiété, sous le nom de \"Syndicat National de l'Amiante de St-Rémi de Tingwick, Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 22 juin 1948.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à St-Rémi de Tingwick, comté d'Arthabaska.Le Sous-secrétaire de la Province, 22073-o JEAN-BRUCHÈSI, Les Utilités Domestiques, Limitée Domestic Utilities, Limited By-Law No.6 (Concerning the increase in the number of Directors) \"Les Utilités Domestiques, Limitée\" \u2014 Domestic Utilities, Limited\" enacts the following: That as from to-day, the number of its directors, which is actually three, will be increased to five.Passed and signed at Quebec, this eighth dav of April, 194S.Unanimously adopted.GEORGES A.LANGLOIS, President.GABRIEL MERCIER, 22071 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat National de l'Amiante de .St-Rémi de Tingwick Inc.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary June 22, 1948.The principal place of business of the said professional syndicate is at St.Rémi de Tingwick, county of Arthabaska.JEAN BRUCHESI, 22073-o Under Secretary of the Province.Aluo Juniors Incorporated Règlement N° 2% H est préposé, secondé et adopté à l'unanimité: Attendu qu'il est dans l'intérêt de la compagnie d'augmenter le nombre des directeurs de 3 à 4; que le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de trois (3) à quatre (4).Montréal, le 27 janvier 1948.(Le Président) et Président de de l'assemblée des directeurs, M.J.SCHAFFER.(Le Secrétaire) et Secrétaire de de l'assemblée des directeurs, 22674-o RUTH RAUCH.Nira Dress Inc.Règlement N° 26 Attendu qu'il y a lieu de diminuer le nombre des directeurs de la compagnie de quatre à trois : En conséquence qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie: Que le nombre des directeurs de la compagnie soit changé en diminuant le nombre desdits directeurs de quatre à trois, dont deux formeront un quorum.Et que le règlement N° 7 soit modifié pour s'y conformer.Daté le deux juin, mil neuf cent quarante-huit.Le Président, S.TAMARIN.Le Secrétaire, 22075-o B.GREENBERG.Aluo Juniors Incorporated By-Law No.23 It was moved, seconded and unanimously passed: Whereas it is in the Company's interest to increase the number of Directors from 3 to 4; that the number of Directors of the Company is increased from three (3) to four (4).Montreal, January 27, 1948.M.J.SCHAFFER, (President) & Chairman, of Director's Meeting.RUTH RAUCH, (Secretary) & Secretary, 22674-0 of Directors Meeting.Nira Dress Inc.By-Law No.26 Whereas it is expedient to decrease the number of Directors of the Company from four to three; Now therefore be it enacted as a By-law of the Company: That the number of Directors of the Company be varied by decreasing the number of such Directors from four to three, two of whom shall form a quorum.And that By-law No.7 de amended to accord herewith.Dated this second day of June, one thousand nine hundred and forty-eight.S.TAMARIN, President.B.GREENBERG.22675-o Secretary. 2046 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 1948, Tome 80, N° 29 Samuel & Samuel Clothing Mfg.Inc.\"Le règlement N° 18 de la compagnie est, par les présentes, amendé en diminuant le nombre des directeurs de quatre à trois, et un quorum de trois à deux.\" Donné à Montréal, ce 23 juin 1948.Témoin: Le sceau corporatif de la compagnie.[Sceau] Le Président, SAMUEL GILBERT.La Secrétaire-trésorier, 22679 ROSE GILBERT, (née Shulmsn) Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Desjardins de Ste-Famille du Cap \", en date du 15 avril 1948, dont le siège social est situé au Cap-de-la-Madeleine, Comté de Champlain, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétaire de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 23 juin 1948.Le Sous-secrétaire de la Province, 22685-o JEAN BRUCHÊSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"L'Entraide Immobilière Laurenticnnc\".en date du 31 mai 1948, dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 8 juillet 1948.Le Sous-secrétaire de la Province, 22686-0 JEAN BRUCHÊSI.Avis est donné que sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 13 juillet 1948, les règlements 1 à 40 inclusivement du \"Club Richelieu Montréal Incorporé\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1941, chapitre 276), telles qu'ajoutées par la loi 11 Geo.VI, ch.65, article 12.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 15 juillet 1948.Le Sous-secrétaire de la Province, 22694-0 JEAN BRUCHÊSI.Club Richelieu Montréal Incorporée Extrait des règlements de la corporation ci-haut mentionnée, tels qu'approuvés par l'honorable Secrétaire de la Province le 13 juillet 1948, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à douze: \"6.Les affaires de l'association seront conduites par un bureau de direction composé de 12 membres.\" Copie conforme.Le Secrétaire, MICHEL-E.ROBILLARD, 22695-0 Notaire.Samuel & Samuel Clothing- Mfg.Inc.\"By-law No.18 of the company is hereby amended by reducing the number of directors from four to three, and a quorum from three to two.\" Enacted, at Montreal, on the 23rd of June, 1948.Witness: the Corporate seal of the Company.[Seal] SAMUEL GILBERT, President.ROSE GILBERT,(nee Shulman) 22679-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secietary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire Desjardins de Ste-Famille du Cap\" under date the 15th day of April, 194S, whereof the head office is at Cap-de-la-Madeleine, county of Champlain, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-third dav of June, 1948.JEAN BRUCHÊSI, 22685-o Under Secretary of the Piovince.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"L'Entraide Immobilière Laurentienne\", under date the thirty-first day of May, 1948, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this eighth dav of July, 1948.JEAN BRUCHÊSI, 22686-0 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary, on July 13, 1948, approved by-laws 1 to 40 inclusively of the \"Club Richelieu Montréal Incorporé\", and such in conformity with the provisions of section 225a of the Quebec Companies Act (R.S.Q., 1941, chapter 276), as added by the Act 11 George VI, chap.65, section 12.Given at the office of the Provincial Secretary, this fifteenth day of July, 1948.JEAN BRUCHÊSI, 22694 Under Secretary of the Province.Club Richelieu Montréal Incorporé Excerpt from the by-laws of the above mentioned corporation, as approved by the Honourable the Provincial Secretary on July 13, 1948, concerning the increase in the number of directors from three to twelve: \"6.The affairs of the association will be managed by a board of directors composed of 12 members.\" True copy.MICHEL E.ROBITAILLE, Notary, 22695 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th, 1948, Vol.80, No.29 2047 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Le Foyer Idéal\", en date du 28 juin 1948, dont le siège social est situé à Coaticook, comté de Stanstead, et que ce document a été déposé dans les urchives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 7 juillet 1948.Le Sous-secrétaire de la Province, 22096-o JEAN BRUCHÊSI.The British Rubder Company Limited Règlement spécial \"A\" \"Que le règlement 10 «les Règh'inents Généraux de la compagnie soit et est par les présentes amendé en augmentant le nombre «les directeurs «le la compagnie de trois à neuf, cimj desquels formeront un quorum\".Nous soussignés, respectivement président et secrétaire-trésorier «le \"The British Rubber Company Limited\" certifions par les présentes que le règlement spécial \"A\" ci-haut mentionné a été adopté à une assemblée des directeurs de la dite compagnie dûment convoquée et tenue suivant les règlements de la compagnie, le trente juin 1948; et que le dit règlement fut subs(''«piemment ratifié, sanctionné et confirmé par les détenteurs «le toutes les actions émises ou courantes «lu capital social «le la Compagnie à une assemblée spéciale générale «les détenteurs d'actions dûment convoquée pour prendre en considération le dit règlement, et tenue le trentième jour de juin, 1948.Signé par nous sous le sceau «le la compagnie ce neuvième jour de juillet, 1948.Le Président, A.L.MAILMAN.Le Secrétaire-trésorier, 22697 W.H.DAVIS.The British Rubber Company of Canada Limited Règlement II-(a) 'TI-(a) Que le règlement II des règlements généraux de la Compagnie soit et est par h s présentes amendé en augmentant le nombre «les «lirecteurs de la Compagnie de neuf à onze, six desquels formeront un qurum\".Nous soussignés, respectivement président et secrétaire de :\"The British Rubber Company of Canada Limited\" certifions par les présentes que le règlement Il-(a) ci-haut mentionné a été adopté à une assemblée des directeurs de ladite Compagnie dûment convoquée et tenue en vertu des règlements de la Compagnie le trentième jour de juin 1948; et que ledit règlement a été subsé-quemment ratifié^ sanctionné et confirmé par les détenteurs de toutes les actions émises et courantes du capital social de la Compagnie, à une assemblée générale spéciale des dits détenteurs dûment convoquée pour prendre en considération ledit règlement et tenue le«Jit trentième jour de juin, 1948.Signé par nous sous le sceau de la Compagnie ce trentième jour de juin, 1948.Le Président, A.L.MAILMAN.-Le Secrétaire-trésorier, 22698 W.-H.DAVIS.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Le Foyer I«l«''al\", under date the twenty-eighth day of June, 1948, whereof the head office is at Coaticook, county of Stanstead, and that the said f the company's capital stock, at a special general meeting of such shareholders duly called to consider the sai«l By-law an«l held on the sai«l 30th day of June, 1948.Witness our hands an«l the seal of the company this 9th dav of Julv, 1948.A.L.MAILMAN, President.VV.H.DAVIS, 22097-o Secretary-Treasurer.The British Rubber Company of Canada Limited By-Law //-(«) \"II-(a) That By-law II of the General By-Laws «;f the Company Ik- and the same is hereby amended by increasing th< number of the Company's Directors from nin« to eleven, six of whom shall form a quorum.\" We, the undersigned, being respectively the President and Secretary u si Ion les directions données à la compagnie en ce qui roganle la distribution par tous les actionnaires «'st pa| U?S présentai autorisée.2.Deux officiels «m directeurs quelconque! «le la compagnie sont par les présentés autorises et «inhumés pour et au nom de la compagnie à signer, exécuter et transmettre, et apposer le sceau «l«- la compagnie à tous tell actes, conventions, documents, instruments et écrite et faire ,-t faire faire tous t«ds actes et «dioscs «pie.à leur discrétion, ils croient opportun afin d'exécuter et donner effet à lu distribution de Ses biens entre ses actionnaires, selon les dispositions précitées dudit règlement**.Certifié vraie copie du règlement spécial \"D\u201e é !i«'té par les directeurs «le Realties Securities Li iiite«l à une assemblée tenue le 91 mai, 1948, et unanimement approuvé à une assemblée générale spéciale des actionnaires «le lauite compagnie dûiiH-nt convoquée afin de oonaidérer tel règlement, et tcm:e le 2S mai, 1948.Montréal.P.Q.Juin le 3.1948.Le Secrétaire, 22099 E.J.HUNTINGTON.Chartes \u2014 Abandon de Abandon de «iiahte Avis est, par les présentes, donné conformément aux dispositions de la 1ère partie «le la Loi des Compagnies de Québec «pie la compagnie J.M.Ix>r«l et Cie Ltée \u2014 J.M.Lord & Co.Lt«l., demandera au Lieutimant-G«>uvorneur d'accepter l'abandon de sa cliarte à une «late qui sera fixée par le Lieutenant-Gouverneur.Daté à Montréal, ce 10 juillet 1948.Le Président, 22678-o EGILLE LORD.Realties Securities Limited AVIS En vertu des dispositions de la loi des Compagnies de Québec, telle qu'amendée, \"Realties Sécurités Limited\" donne avis, par les présentes, qu'elle fera application à l'honorable Procureur Général de la Province de Québec pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en onlonne son annulation, et fixe une «late à compter de laquelle elle sera dissoute.Montréal, P.Q., le 3 juin 1948.Le Secrétaire, 22700-o E.J.HUNTINGTON.General Steamships Terminals Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie ci-dessus demandera la permission d'a- Realties Securities Limited Special By-Law \"D\" A by-law to authorize the distribution of the Company's Assets.Be it and it is hereby enacted as follows: 1.The distribution of the assets of the Company rateably among the Shareholders in accordance with their respective rights or in accordance with the directions for listribution given to the Company by all the Shareholders is hi reby authorised.9, Any t wo Officers or Directors of the C«unpany are hereby authorized ami directed for and on behalf and in the name of the Company to sign.execute and deliver, and affix the sea) of the Company to, all such deeds, agreements, documents, instruments and writings and do and perform or Cause to Ik' done and performed all such acts and things as they, in their ii, may consider t«> be expedient f«»r the purpose of carrying out and giving effect to the distribution of its assets amongst its Shareholders in accordance with the foregoing provisions of this By-law.\" Certified to Ik- a true copy «.f Special By-law \"D\" enacted by the Directors of Realties Securities Limited'* at a meeting held OB May 21st, 1948, and unanimously approved at a Special Genera] Meeting of the Shareholders of said Con puny duly called f«ir the pi rpose of considering such by-law ami held on May 2 th, 194>.Montreal, P.Q., June 3rd, P.4S.E.J.HUNTINGTON, 22099-b Secretary.Charters \u2014 Surrender of Surrender of charter Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Part I of the Quebec Companies Act, the company \"J.M.Lara et Cie Ltée \u2014 J.M.Lord & Co.Ltd.\", will apply to the Lieutenant-Governor for leave to sunender its chartet from a date to be fixed by the Lieutenant-Governor.Dated at Montreal, this 10th dav of Julv, 1948.EGILLE LORD, 22078-o President.Realties Securities Limited NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act, as amended, \"Realties Securities Li-mited\" hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney General of the Province of Quebec for acceptance of the surrender of its charter and from which it shall be dissolved.Montreal, P.Q., June 3rd, 1948.E.J.HUNTINGTON, 22700-o Secretary.General Steamships Terminals Limited Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies' Act, the above QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Jul,/ 17th, 191,8, Vol.80, No.29 2049 hundonncr sa Charte conformément à la lx>i Company will make application for leave to sur- iles (Compagnies de Québec.render its Charter.Trois-Rivièrcs, P.Q., Juillet, 7, 1948.Trois-Rivières.I\\Q., July 7.1948.La Secrétaire.JOS.ST-ÀNTOINE.2966A-0 JOS.ST-ANTOINE, 99665-0 Secretary.Département des Affaires n unicipales Départaient of Municipal Affairs Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 5 uvril 1948 du conseil du canton Trécesson, comté d'Ahitihi, et conformément aux dispositions de l'article 130 «lu Code municipal, il a autorisé, en date «lu !) juillet 1948, «pie lea publications de tous lec; En consequence^ avis est par les présentes donné que le permis et certificat d'enregistrement No 3024 de The Gibraltar Fire and Marine Insurance Company est annulé à compter du 1er juin 1948.Donné au bureau du Service des assurances, Département du Trésor, le 29 juin 1948.Pour le Trésorier de la Province, GEORGES LAFRANCE, 22616-28-2-0 Surintendant des assurances.entered into by these two corporations the 24th of February 1948, to take effect as from the 1st of June 1948; and Whereas The New Brunswick Fire Insurance Company has complied, pursuant to the said agreement of merger, with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Therefore, notice is hereby given tliat the license and certificate of registiy No.3032 of The New Brunswick Fire Insurance Company is cancelled as from the 1st of June 1948.Given at the office of the Insurance Branch, Treasury Department, the 29th of June 1948.For the Treasurer of the Province, GEORGES LAFRANCE, 22010-28-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Cancellation of Licence and Registration Whereas The Franklin Fire Insurance Company of Philadelphia, whose hea«l office was situate in Philadelphia, State of Pennsylvania, United States of America, has ceded all its assets ami transferred all its liabilities to the Home Insurance Company whose head office is situate in New York, State of New York, United States of America, as provide*! in an agreement of merger entered into by these two corporations the 24th of February 1948, to take effect as from the 1st of June 1948; and Whereas The Franklin Fire Insurance Company of Philadelphia has complied, pursuant to the said agreement of merger, with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Therefore, notice is hereby given that the licence and certificate of registry No.3022 of the Franklin Fire Insurance Company of Philadelphia is cancelled as from the 1st of June 1948.Given at the office of the Insurance Branch, Treasury Department, the 29th of June 1948.For the Treasurer of the Province, GEORGES LAFRANCE, 22610-28-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Cancellation of License and Registration Whereas The Gibraltar Fire and Marine Insurance Company whose head office was situate in New York, State of New York, United States of America, lias ceded all its assets and transferred all its liabilities to the Home Insurance Company whose head office si situate in New York, State of New York, United States of America, as provided in an agreement of merger entered into by these two corporations the 24th of February 1948, to take effect as from the 1st of June 1948; and Whereas The Gibraltar Fire and Marine Insurance Company has complied, pursuant to the said agreement of merger, with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Therefore, notice is hereby given that the license and certificate of registry No.3024 of The Gibraltar Fire and Marine Insurance Company is cancelled as from the 1st of June 1948.Given at the office of the Insurance Branch, Treasury Department, the 29th of June 1948.For the Treasurer of the Province, GEQRGES LAFRANCE, 22616-28-2-0 Superintendent of Insurance. 2056 A vis uk renouvellement ue certificat d'eN-reuistremen't Axis est donné pur les présentes «pie le certificat e accompanied by an accepted choque equal to 1% of the'amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not inclmle accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered ut a meeting of the school commissioners for the municipality of the parish of St-Hubert, to be held on Wednesday the fourth day of the month of August, 1948, at seven o'clock in the evening, at the Catholic Schools' Office of the parish of St-Hubert.The School Commissioners for the Municipality of the Parish of St-Hubert do not hind themselves to accept the highest nor any of the tenders.St-Hubert, this fifteenth dav of Julv, 1948.HUBERT ROCHELEAU, 22692 Secretary-Treasurer.Province of Quebec School Commissioners for the Municipality of Amos, County of Abitibi-East Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will l>e received by the undersigned up to four o'clock in the afternoon, Wednesday the fourth day of the month of August, 1948, for the purchase of $550,000 of bonds of the School Commissioners for the Municipality of Amos, County of Abitibi-East, dated the 1st of August, 1948, and redeemable serially from the 1st of August, 1949, to the 1st of August, 1963, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3J^% per annum, payable semi-annually the 1st of February and 1st of August of each year.The rate of interest offered may be the same or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: i Tableau d'amortissement\u2014$550,000.00\u201415 ans Annie Capital 1er août 1949 .x$ 30,500.00 1er août 1950 .x 31,500.00 1er août 1951 .x 32,500.00 1er août 1952 .x 33,500.00 1er août 1953 .x 35,000.00 1er août 1954.x 36,000.00 1er août 1935.x 37,500.00 1er ao» 1956 .x 3&500 00 Table of Redemption\u2014$560,000.00\u201415 years Year Capital 1st August, 1949 .x$ 30,500.00 1st August, 1950 .x 31,500.00 1st August, 1951 .x 32,500.00 1st August, 1952 .x 33,500.00 1st August, 1953 .x 35,000.00 1st August, 1954 .x 36,000.00 1st August, 1055 ,.x 37,500.00 1st August, lïfô6.x d&btXLOO 2064 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 191$, Tome 80, N° 29 1er août 1957 .x 40,000.00 1er août 1958 .x 41,500.00 1er août 1959 .7,000.00 1er août 1900 .7,000.00 1er août 1961 .7,500.00 lei-aoûtl902 .7,500.00 1er août 1903 .164,500.00 Le x indique les versements d'un octroi au montant total de $300,404.25 promis par le Secrétaire de la provinee et payable en six versements annuels de $36,040.42 et un dernier versement de $36,040.47.Le capital et les intéiêts sont payab'es à la banque dont le nom est mentionné dans a procédure d'emprunt, à Montréal, Québec ou Amos.Lesdites obligations ]>ourront, en vertu du chapitre 212, Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, au puir, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les éclu*ances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du mo liant de l'emprunt et devra.spé*cifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts uccrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles pour la municipalité d'Amos qui sera tenue mercredi le quatrième jour du mois d'août 1948.à huit heures de l'après-midi, au bureau du secrétaire-trésorier.Les commissaires d'écoles de la municipalité d'Amos .-e réservent le droit de n'ac.-epter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Amos, ce quinzième jour de juillet 1948.Le Secrétaire-trésorier, 22691-o El).BÉDARD, A.P.A.1st August, 1957 .x 40,000.00 1st August, 1958.x 41,500.00 1st August, 1959 .7,000.00 1st August, I960 .7,000.00 1st August.1901 .7,500.00 1st August.1902 .7,500.00 1st August, 1903 .104,500.00 The letter x indicates payments of u grant to the total amount of 1860*404 ¦ 25 promised by the Pro vine al Secretary and payable in six annual instalments of $30 0-10.42 and a final instalment of $36,046.47.Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Amos.The said bonds may, under chapter 212, Reviled Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, at par, on any interest payment date; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called iu reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify wiiether the price offered ncludcs or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners for the municipality of Amos, to be held on Wednesday, the fourth day of the month of August, 1948, at eight o'clock in the evening, iu the office of the Secretary-Treasurer.The School Commissioners for the Municipality of Amos, do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Amos, this fifteenth duy of July, 1948.El).BEDARD A.P.A., 22091 Secretar y-trcasurer.Commissaires d'Ecoles pouh la Municipalité School Commissioners for the Municipality de la ville de saint-Ji.rô.mk of the town of SaINT-JÉUÔME (Comté de Terrebonne) (County of Terrebonne) Avis est, par les présentes donné, que des soumissions cachetées, marquées sur l'enveloppe \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné*, au bureau de la commission scol ire de la ville de Saint-Jérôme, dans le comté de Terrebonne, P.Q., Canada, 280 rue Labelle, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, le 12 août 194S, pour l'achat d'un montant de $235,000.00 en sériel 20 ans, datées du 1er septembre 1948 et émises sous l'autorité d'une résolution de la Commission Scolaire de cette ville, le 20 mai 1948.Les dites obligations porteront intérêt au choix du soumissionnaire dont l'offre sera uccepté-e, aux taux soumis n'excédant pas 3d^% et le taux offert peut être le même pour l'émission totale ou |>eut varier suivant l'échéance.L'intérêt sera payable semi-annuellement.Tableau de rachat\u2014$235 Date 1er septembre 1949.1er septembre 1950.1er septembre 1951.1er septembre 1952.1er septembre 1953.1er septembre 1954.1er septembre 1955.1er septembre 1950.1er septembre 1957.1er septembre 1958.1er septembre 1959.1er septembre 1960.1er septembre 1901.000.00\u201420 ai Capital x$ 12,500.00 13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 15,500.00 16,000.00 16,500.00 17,000.00 7,500.00 .8,000.00 8,000.00 Notice is hereby given the sealed tenders, endorsed on the envelope \"Tenders for bonds'' will be received by the undersigned, at the office of the School Commissioners for the Municipality of the town of Saint-Jérôme, county of Terrebonne.280 Lab'.'lle sireet, up-to four o'clock in the afternoon the twelfth of August 1948, for the purchase of an amount of $231,000.00 of bonds 20 years series, dated the first of September 1 41 and issued under authority of a resolution of the School Commissioners of the said town the 20th of May 1948, he said bonds will liear interest at the option of the tender whose offer shall be accepted at the :j.te submitted, not exceeding 3J-£%, and the rate offered may he the same for to* total issue or may \\ j ry according to maturities.Interest will be p yable semi-annually.Tt.bte of Redemption\u2014$235,000.00\u201420 yearn.Year Capital Septen ber 1, 1949.xS12,500.00 September 1, 1950.x 13.000.1H) September 1, 1951.x 13,500.00 Septemlxr 1.1952.x 14,000.00 September 1, 1953.x 14,500.00 September 1, 1954.x 15,000.00 September 1.1955.x 15.500.00 Septen ber 1, 1956.x 16,000.00 S< ptember 1, 1957.».x 16,500.00 September 1, 1958.x 17,000.00 September 1, 1959.7,500.00 September 1, 1960.8,000.00 September 1, 1961.8,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th 191$, Vol.HO, No.29 2065 1er septembre 1962.8,600.00 1er septembre 1963.8,500.00 1er septembre 1904.9,000.00 1er septembre 1905.9,000.0:) 1er septembre 1900.9,500.00 1er septembre 1967.9,500.00 1 er septembre 1908.10,000.00 Le x indique les versements d'un oetroi un montant total de §100,000.00 promis par le Secrétaire de lu province et payable en dix versements annuels de «10,000.Le capital et les intérêts seront payables à Saint-Jérôme ou à Montréal à lu banque mentionnée aux procédures d'emprunt.Ces obligations seront émises par coupures «le $1,000.00 et «le 8500.00.Les dites obligations pourront, en vertu de l'autorité du chapitre 212, «les Statuts Refondus do Québec, 1941, être rachetées par anticipation, au pair, à toutes échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéance* les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Les soumissions semnt prises en considération à la session spéciale des Commissaires d* Ecoles du 12 août 1948, à huit heures du soir à leur bureau, rue Labelle.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chè«pie visé «''gai à 1% «lu montant de l'emprunt.L'intérêt couru sur les obligations devra s'ajouter au prix offert au moment «le la livraison.LéS Commissaires d'Ecoles «le la ville «le Saint-Jérôme se réservent le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Jérôme, ce treize juillet mil neuf cent quarante-huit.Le Sécrétai re-Trésorier, 22090-o C.VIAU.September 1,1902.8,500,00 September 1, 1903.8,500.00 September 1, 1904.9,000.00 September l, 1905.9,000.00 September 1, 1900.9,500.00 September 1, 1907.9,500.00 September 1, 1908.10,000.00 The letter x indicates payments of a grant to the total amount of $100,000.00 promised by the Provincial Secretary and payable in ten annual instalments r $10,000.00 each.Hot h the principal of these bonds and the in-tcr«'st thereon will be payable at Saint-Jérôme or at Montreal at the hank mentioned in the loan procedure.The bonds will be issued in the f August, 1948, at eight oelock p.m., at their office 280 Labelle Street, Saint-Jérôme.Each tender must be accompanied by a certi-fied cheque equal to [% of the amount of the loan.The accrued interest on the bonds must be added to the price of the bonds at the time of their delivery.The School Commissioners do not hind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Saint-Jérôme this 13th dav of\"Julv 1948.22690-o C.VIAU, Secretary-Treasurer.Province de Québec Province of Quebec Commissaires d'Écoles pour la mi ' nu ip alité School Commissioners for the Municipality de ST-M vxime et ST-Jos.\\PHAT de Lo.nul euil, of ST-M axime AND St-JoSAPHAT DE LoNGUEUIL, Comté de Chamuly County of Chambly Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées ''Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné jusqu'à quatre heures de l'après-midi, lundi le neuvième jour du nuis d'août 1948, pour l'achat «le $153,500.00 d'obligations «les commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Maxime et St-Josaplmt «le I^ongueuil, comté de Chambly, datées du 1er juillet 1948 et remboursables en séries du 1er juillet 1949 au 1er juillet 19GS inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3' 2% par année, payable seini-annuellcmcnt les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt offert peut être le même ou peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant : Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be receiv-e«l by the undersigned up to four o'clock in the afternoon, Monday, the ninth day of the month of August, 1948, for the purchase of $153,500 of bonds of the School Commissioners for the Municipality of St-Maxime and St-Josaphat de Longueuil, County of Chambly, dated the 1st of July, 1948, and redeemable seri lly from the 1st « f July, 1949, to the 1st of July, 1908, inclusively, with interest, at a rate not exceeding 33^% per annum, payable semi-annually the 1st of January and 1st of July of each year.The rate of interest offered may be the same or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement $163,000.00\u201420 ans Table of Redemption\u2014$158,500.00\u201420 years Année Capital Year Capital 1er juillet 1949.x$ 9,500.00 1st July, 1949.x$ 9,500.00 1er juillet 1950.x 10,000.00 1st July, 1950.x 10,000.00 1er juillet 1951.x 10.000.00 1st July, 1951.x 10,500.00 1er juillet 1952.x 10,500.00 1st July, 1952.x 10,500.00 1er juillet 1953.11,000.00 1st July, 1953.x 11,000.00 1er juillet 1954.x 11,00.00 1st July, 1954.x 11,500.00 1er juillet 1955.x 12,000.00 1st July, 1955.x 12,000.00 1er juillet 1956.2,\".00.00 1st July, 1956.2,500.00 1er juillet 1957.2,.00.00 1st July, 1957.2,500.00 1er juillet 195S.2,500.00 1st July, 1958 .2,500.00 2066 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 191$, Tome 80, N° 29 1er juillet 1939 .2.500.00 1er juillet 1960.2.500.00 1er juillet 1961.2.500.00 1er juillet 1902 .3.000.00.1er juillet 1903 .3,000.00 1er juillet 1904.3,000.00 1er juillet 1965.3,000.00 1er juillet, 1900.3,000.00 1er juillet 1907 .3*500.00 1er juillet l'JfiS.45.000.00 Le x indique les versements d'un octroi au montant total de $70,202, promis par le Secrétaire de la province et payable en sept versement! unnuels de $10,880 chacun.Le capital et les intérêts sont payable! à lu banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, Québec ou St-Lambert.Lesditcs obligations pourront, en vertu du chapitre 212.Statuts relpndus de Québec.1941, être rachetées par anticipation, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérée! à une séance spéciale des commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Maxime et St-Josa-phat de Longueuil qui sera tenue le neuvième jour du mois d'août 1948, à S.30 heures de l'après-midi, à l'école St-Maxin,ilien, rue St-Louis, St-Maxime, (Chambly).Les commissaires d'écoles de la municipalité de St-Maxime et St-Josaphat de Longueuil ne s'engagent à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Maxime, ce quinzième jour de juillet 1948.(Comté de Chumbly).Le Secrétaire-trésorier, O.THÊROUX, 93, rue Charron, St-Maxime, 22693-0 (Chambly).1st July, 1959.2,500.00 1st July, 1960 .2,500.00 1st July, 1961.2,500.00 1st July, 1962 .3,000.00 1st July, 1963.3,000.00 1st Julv, 1964 .3,000.00 1st July, 1965 .3,000.00 1st July, 1966 .3,000.00 1st July, 1907 .3,500.00 1st July, 1908 .45,000.00 The letter x indicates payments of a grant to the.total amount of $76,202, promised by the Provincial Secretary and payable in seven annual instalments of $10,880 each.Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or St-Lambert.» The said bonds may, under chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, -at par, on any interest payment «late; however, if such redemption be partial, the bonds to be retlecmed will be called in reverse order of maturity ami serial number.Each tender must be accompanie«l by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan ami must specify whether the price offere«l include! or docs not include accrued interest on the l>onds to time of their «lelivery.Tenders will be opened ami considère»! at a special meeting of the school commissioners for tlie municipality of St-Maxime and St-Josaphat de Longueuil, to l>e held on the ninth day of the month of August, 1948, at 8.30 o'clock in the evening, at the St-Maximilien School, St-Louis Street, St-Maxime, (Chambly).The School Commissioners for the Municipality of St-Maxime and St-Josaphat de Ixmgueuil do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.St-Maxime, this fifteenth day of July, 1948.(County of Chambly) O.THÊROUX, Secretary-treasurer.93, Charron Street, St-Maxime, 22093 (Chambly).Vente \u2014 Loi de faillite LOI DE FAILLITE Canada, province de Québec, district de Québec.Cour Supérieure, \"En Matière de Faillite\".VENTE A L'ENCAN Dans l'affaire de J.Roméo Rochon, commerçant d'animaux, 37, rue Crémazie, Québec, Que.Débiteur.Avis est par le présent donné que LUNDI, le 2 AOUT 1948, à 11 (onze) heures de l'avant-midi, (heure avancée) sera vendu par encan public, aux bureaux des syndics soussignés, 111, côte de la Montagne, Québec, l'immeuble de cette faillite ci-après décrit: Item A.Le lot numéro soixante-trois des redivisions du lot originaire quatre mille trois cent-quatre-vingt-un (4381-63) du cadastre officiel du quartier Montcalm de la Cité de Québec, étant un terrain situé sur le côté sud de la rue Crémazie, (numéros civiques 37, 373^, 39) mesurant vingt-cinq, pieds de front sur environ qua- Sale \u2014 Bankruptcy Act THE BANKRUPTCY ACT \"Canada, Province of Quebec, District of Quebec.Superior Court.\"Sitting in Bankruptcy\".AUCTION SALE In the matter of J.Roméo Rochon, Cattle-foaler, 37 Crémazie Street, Quebec, Que., Debtor.Notice is hereby given that on MONDAY, AUGUST 2, 1948, at 11 (eleven) o'clock in the Perenoon, (Daylight Saving Time) there shall be sold by public auction at the offices of the undersigned trustees, 111 Mountain Hill, Quebec, the immovable in this bankruptcy, hereinunder described : Item A.Lot number sixty-three of the redivisions of original lot four thousand three hundred and eighty-one (4381-63) of the official cadastre for Montcalm ward of the city of Quebec, being a lot of land situate on the south side of Crémazie Street, (civic numbers 37, 37^, 39) measuring twenty-fivfe feet in front by ninety-four feet in QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, 19*8, July 17th, Vol.80, No.29 2067 tre-vingt-quatorze pieds de profondeur, avec la maison et dépendances dessus construites et droit de passage en tout temps, à pieds et en voiture, en commun avec ceux y ayant droit, dans les ruelles connues sous les numéros 4381-57E, 3761-6A et 6B du même cadastre, et sujet à la rente foncière en faveur de l'Hôtel-Dieu de Québec.Cet item sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur.Conditions de paiement: argent comptant.Les titre et certificat peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.La vente de cet item est faite conformément aux articles sept cent seize et sept cent dix-sept du Code de Piocédures Civiles et à l'article quarante-cinq de la Loi de Faillite; cette vente équivaut à la vente au Shérif.Québec, Que., le 21 juin 1948.Les Syndics, Lefaivre, Marmette & Lefaivre, Bureaux: 111, côte de la Montagne, Québec, Que.22535-26-2-o depth \u2014 with the house and dependencies thereon elected, ami right of way at all times, on foot and in vehicle, in common with those having rights, therein, in the lanes known under numbers 43N1-57E, 3761-6A and 6-B of same cadastre and subject to the ground rent in favour of l'Hôtel-Dieu de Québec.This item shall be offered for sale to the highest and last bidder.Conditions of payment: Cash.Titles and certificate may be examined at any time by applying at the offices of the undersigned trustees.The sale of said item is made pursuant to articles seven hundred and sixteen and seven hundred and seventeen of the Code of Civil Procedure and to section forty-five of the Bankruptcy Act: said sale having the effect of a Sheriff's Sale.Quebec, Que., June 21, 1948.Lefaivre, Marmette & Lefaivre, Trustees.Offices: 111, Mountain Hill, Quebec, Que.22535-26-2 Vente par licitation Sale by Licitation Canada, Province de Québec, District de Ka-mouraska, Cour Supérieure, N° 160FG.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour \"Supérieure siégeant à Rivière-du-Loup, dans le district de Kamouraska, le 5 août 1940, dans une cause dans laquelle Onésime Rioux, bourgeois de Trois-Pistoles, et Léon-A.La voie, de la ville de Fall River, États-Unis d'Amérique, sont demandeurs, ordonnant la licitation de certains biens immeubles désignés comme suit, savoir: 1.Une étendue de terre à être vendue comme un tout et composée des deux parties suivantes: a) Cette partie des lots numéros 145 et 148 au cadastre officiel pour la paroisse de Trois-Pistoles, bornée au sud à la propriété en deuxième lieu décrite à une clôtufe en broche en travers de la dite terre à environ 75 pieds au nord de la ligne de transmission électrique et sensiblement en ligne avec le poteau au coin nord-est du terrain où sont les transformateurs de la compagnie de Pouvoir du Bas St-Laurent, bornée au sud au reste du lot 145, au nord aux lots 134, 135, 138.139, 140, 141, 142, 144, à l'est aux lots numéros 135, 136 et 111, à l'ouest aux lots numéros 144, 170, 171 et 180 avec la maison y érigée^ appartenances et dépendances, sujette la partie 148 au droit de passage réservé à la succession David Bertrand; 6) Les lots numéros 133, 134, 135 et 139 au cadastre officiel pour la paroisse de Trois-Pistoles, appartenances et dépendances à distraire du lot 139, l'emplacement de Mlle Jeanne Rioux, tel que clôturé.2.Une autre partie de terre située au premier rang de Trois-Pistoles, bornée au sud au troisième rang et au circuit Bertrand, à l'est partie au circuit Bertrand et partie à Théodore D'Amours, à l'ouest à Dame veuve J.-A.Lévesque, au terrain du couvent, au terrain d'Arthur Deschênes, au terrain appartenant à la succession Nazaire D'Am'ours èt aux drVers emplacements longeant Canada, Province of Quebec, District of Kamouraska, Superior Court, No.16016.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting at Rivière-du-Loup, in the district of Kamouraska, on the fifth of August, 1946, in a case wherein Onésime Rioux, gentleman, of Trois-Pistoles, and Léon A.La-voie, of the city of Fall River, United States of America, arc plaintiffs, ordering the licitation of certain immovable properties described as follows, to wit: 1.A tract of land to be sold as one single lot and composed of the following two parts: a) That part of lots num its 145 and 148 of the official cadastre for ihe perish of Trois-Pistoles, boun led on the fout i by the property secondly descibrd at a wire fence crossing the said land at about 75 feet north of the el< ctric transmission line and evidently in Hi e wti the pole at the north', ast corner of the land where the transformers of tic Lower St.Lawrence Power Company (Compagnie do Pouvoir du Bas St-Laurent) are situate; 1 o mded on the south by the residue of lot 145, on the north by lots 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 144, on the cas*, by lots number 135, 136 ad ill, on the west by lots numbers 144, 170, 171 and 189 \u2014with the house thereon erected, appurtenances and dependencies, the part 148 being subject to a right of way reserved for the Estate David Bertrand; b) Lots numbers 133, 134, 135 and 139 of the official cadastre for the Parish of Trois-Pistoles, appurtenances and dependencies, to be deducted from lot 139, the emplacement of Mile Jeanne Rioux, as fenced in.2.Another portion of land situate in the first range of Trois-Pistoles, bounded on the south by the third range and by the Bertrand boundary line, on the east by the Bertrand boundary line and partly by Théodore D'Amours, on the west by Dame widow J.A.Lévesque, the land of the convent, the land of Arthur Deschênes, the land belonging to the Estate Nazaire D'Amdurs and 9088 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 191,8, Tome 80, N° 29 ladite terre dans la ville, au nord à lu clôture de broche séparant cette partie de terre de celle ci-après en premier lieu désignée, étant connue comme partie des lots 145, 146, 14S, 188, 134, 135 et 139 au cadastre officiel pour la paroisse de Trois-Pistoles.3.Un certain terrain au premier rang île la paroisse de Ste-IYançoise, d'un arpent et demi de largeur au bas et trois arpents de largeur au haut, sur onze arpents «!«\u2022 profondeur, borné un nord au fronteau des terres du 3e rung de Trwis-l'is'o-let, à l'est partie au lot 122, partie au lot 129 et partie au lot 132, à l'ouest à Clément Chassé ou représentant, connu et désigné au cadastre officiel pour lu paroisse de Ste-Fran«;oise, district de Kamouruska, comme partie du lot numéro 133.Les dits immeubles seront mis à l'enchère «4 adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, le 3 SEPTEMBRE 1948, à 2 heures de l'après-midi «levant le Protonotairc de la Cour Supérieure, dans la salle d'uudience «lu palais «le justice «le Rivière-du-Loup, sujets aux charges.«Causes et conditions indiquées dans lecanierdes charges déposé au greffe «lu l'rotonotaire «le la dite cour.Les oppositions à la vente, s'il y avait lieu, f Ste-Françoi.se, «Iistrict of Kamouraska, as part of lot number 133.The said immovabhs will be sol«l by auction and adjmiged to the highest and last bidder, on the Till H D of SEPTEMBER, 1948, at TWO «>Ylock in the afternoon, before the Prothonotary of the Superior Court, in the Court Room of the Court House of Rivière-du-Loup.subject to the «\u2022barges, clauses and conditions indicated in tin-list of charges filed in the office of the Prothonotary of the said Court.Oppositions to the sale, if any, must be filed at the latest on the 12th day before the date of the licitation, and oppositions for payment must be file«l six days after the adjudication, on pain of forfeiture.Rivière-du-Loup, June 23, 1948.(Signed) Gagnon & Gagxon, 22672-29-2 Attorneys for plaintiffs.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LAND and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court, District of Arthabaska Arthabaska, to wit: \\ T.S.GIROUX LIMI-No.5271 ] J TÉE, a body politic and incorporate, having a business office in the city of Drummondville, district of Arthabaska, plaintiff; vs FILIX LAUZIÈRE, workman, of the same place, defendant.As belonging to the defendant: The undivided half of lot number sixty-one (No.61) of the official subdivision of lot number one hundred and thirty (No.130) on the official cadastral plan am! in the book of reference of the township Grantham, county of Drummond, for the second range, with buildings thereon erected.To be sold at the church door of the parish of St-Frédéric de Drummondville, county of Drummond, on the TWENTY-SEVENTH day of JULY, 1948, at TWO o'clock in the afternoon (Daylight Saving Time*).MAURICE MAHEU, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, June 17, 1948.22555-26-2 [First insertion, June 26, 1948] QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.Jul,/ 17th, 191,8, Vol.80, No.29 2009 K A MOL It ASK A Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure ( 'anada, ( T>IA N KETT - WEBS- Province de Québec, ) *¦ TER L II M B E R District de Montréal.1 COMPANY INCORPO- N° 257474 1 RATED, corporation commerciale, avant le lieu de ses affaires duns les cité et «Iistrict «le Montréal, vs WILLY RIOUX, d ! l'endroit appelé \"Lac Sauvage\" dans la paroisse de St-Michel de S«piatteck, «Iistrict de Kumouras-ka.défendeur.\"Un lot «le terre situé dans le canton Kobitaillc.portant le numéro vingt-neuf (29) du rang un (1) contenant quatre-vingt -dix-sept (97) Actes, avec, bâtisses dessus construites, circonstan es et dépendances, à distruire cependant du «lit lot, un arpent en superficie appartenant à Eugène Malenfant, soit un arpent «le front par un arpent de profondeur! borné en front à l'est, à la route, au sud.par le ruisseau qui s'y trouve, à l'ouest et au nord par le reste «iu dit lot numéro vingt-neuf (39) sus décrit.\" Pour être vemlu à la porte de l'église «le la paroisse «le St-Micbel du Squattcck, Témiscouata, VENDREDI, le VINGTIEME jour ùu mois d'AOUT 1948, à TROIS heures «le l'après midi.Le Shérif, HENRI MI( HAUD.rf Bureau du Shérif, Rivière-du-ljoup, le S juillet 194S.22682-29-2-0 [Première insertion, 17 juillet 1948] KAMOl RASKA Fieri Facias de Bonis et ds Terris Superior Couit Canada, ( DLUNKETT - WEBS.Province of Quebec, ) *\u2022 TER L U M B ER District of Montreal, ) < OM PAN Y INCOR-No.257474 {PORATED, a commercial corporation having its place of business in the city ami district of.Montreal; vs WILLY RIOUX, of the place called \"Lac Sauvage\" in the parish of St-Miehel de Squattées:, «Iistrict of Kamouraeka, defendant.A lot of land situate in the township Robitaille, bearing number twenty-nine (29) of range one (1), containing ninety-seven (97) acres, with buildings l hereon erected, circumstances and dependencies; to be deducted, however, from said lot, one arpent in area belonging to Eugène Malenfant, namely one arpent iu front by one arpent in depth, bounded in front to the east, by the highway, on the south, by the stream there situate on the west and north by the residue of sai«i lot number twenty-nine (29) above described.To be sold at the church door of the parish of St.Michel de Squattcck, Témiscouata, on FRIDAY, the TWENTIETH dav of the month of AUGUST, 1948, at THREE o'clock in the afternoon.?HENRI MICHAUD, Sheriff.Sheriff's Office, Rivière -du-Loup, July 8, 1948.22682-29-2 [First insertion, July 17, 1948] QUÉBEC QUEBEC Fieri Facias Québec, à savoir: ^RMAND AUGER, AN- N° 55070.I * *¦ TOINE AUGER, RENÉ AUGER et LOUIS AUGER, tous quatre commerçants, des cité et district de Québec, y faisant affaires ensemble en société comme marchands de bois sous les nom et raison sociale de \"Auger & Auger\"; contre PRE FAB INC., corps politique et incorporé ayant sa principale place d'affaires dans les cité et «Iistrict de Québec, et CANADIAN NATIONAL RAILWAYS, corporation légalement constituée ayant son siège social dans les cité et district de Montréal et une place d'affaires dans les cité et district de Québec, et AURELE LECLERC, des cité et district de Québec, en sa qualité de régistrateur pour la division d'enregistrement de Québec, mis-en-cause, à savoir: La manufacture ou usine construite sur le lot N° 376 (trois cent soixante-seize) du cadastre officiel pour la paroisse de Sainte-Foye, comté «le Québec, et située sur les terrains du Canadian National Railways, près du pont de Québec, circonstances et dépendances.Ladite défenderesse détient à ce sujet un bail dudit Canadian National Railways.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de Sainte-Foye, comté de Québec, le SIXIEME jour d'AOUT prochain, à DIX heures du matin (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, AIMÉ DION.Québec, 30 juin 1948.22588-27-2-o (Première insertion: 3 juillet 1948] Seconde insertion: 17 juillet 1948] Fieri Facias Quebec, to wit: j A RM AND AUGER, AN-No.55070.} \" TOINE AUGER, RE-NÉ AUGER and LOUIS AUGER, all four merchants, of the city and district of Quebec, carrying on business together in partnership as lumber merchants, under the firm name and style of \"Auger & Auger\"; against PRE FAB INC., a body politic an«l corporate having its principal place of business in the city and «Iistrict of Quebec, and CANADIAN NATIONAL RAILWAYS, a body politic and corporate having its head office in the city and «Iistrict of Montreal and a place of business in the city and «Iistrict of Quebec, and AURELE LECLERC, of the city and district of Quebec, as registrar for the Registration Division of Quebec, mis-en-cause, to wit: The factory or plant built on lot No.376 (three hundred and seventy-six) of the official cadastre for the parish of Sainte-Foye, county of Quebec, and situate on the Canadian National Railway land, near the Quebec Bri«lge, circumstances and dependencies.The said defendant holds a lease regarding same, from the said Canadian National Railways.To be sold, at the parochial church door of Sainte-Foye, county of Quebec, on the SIXTH day of AUGUST next, at TEN o'clock of the forenoon (Daylight Saving Time).AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, June 30, 1948.22588-27-2 [First insertion: July 3, 1948] [Secoud insertion: July 17, 1948] 2070 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 191$, Tome 80, N° 29 lé U fiaieti* «UitisUt te|i4kHll29 Actions en séparation de biens: Boisvert vs O'Malley.2044 Masse vs Couturier.2044 Parenteau vs Lamy.2044 Arrêtés en Conseil: 926 \u2014 Concernant la Société des Artisans, L'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport et la \"Loi pour améliorer les conditions de l'habitation\".2043 974 \u2014 Industrie du meuble duns lu province tie Québec.'.2030 Avis aux intéressés : 2022 Avis d/vers: Algo Juniors Incorporated (Directeurs) 2045 Club Richelieu Montréal Incorporé (Directeurs).2040 Club Richelieu Montréal Incorporé (Règlements).2040 La Caisse Populaire Desjardins de Ste-Famille du Cap (Fondation)- 2046 La Fraternité Nationale Catholique du Transport de Quelle Inc.(Nom changé).2044 Le Foyer Idéal (Fondation).- 2047 L'Entraide Immobilière Laurentienne (Fondation).2040 Les Utilités Domestiques, Limitée \u2014 Domestic Utilities, Limited (Directeurs) .2045 Le Syndicat National Catholique du Textile du Cap-de-la-Madeleine Inc.(Mason Spinning-Laurentian Silk) (Formation).2044 Nira Dress Inc.(Directeurs).2045 Realties Securities Limited (Distribu- bution de l'actif).2048 Samuel & Samuel Clothing Mfg.Inc.(Directeurs).2040 Syndicat National de l'Amiante de St-Rémi de Tingwick Inc.(Formation) .\u2022 \u2022 \u2022 2045 The British Rubber Company Limited (Directeurs).2047 The British Rubber Company of Canada Limited (Directeurs).2047 Chartes \u2014 Abandon de: General Steamships Terminals Limited.2048 J.M.Lord et Cie Ltée \u2014J.M.Lord & Co.Ltd.2048 Realties Securities Limited.2048 DEPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Affaires Municipales: Trécesson, canton de.2049 Agriculture: Industrie Laitière: Ordonnance No 1-48D \u2014 Montréal.2050 Ordonnance No 48-Sp-VI \u2014 Cantons de l'Est.2049 t*An o! the ti*tf OfficW fimtti, sfc.29 Actions for Separation as to Property: Boisvert vs O'Malley.2044 Masse vs Couturier.2044 Parenteau vs Lamy.2044 Orders in Council: 926 \u2014 Concerning the \"Société des Artisans, L'Union St-Joseph de Notre-Dame de Beauport\" and the \"Act to improve Housing Conditions\".2043 974 \u2014 Furniture industry in the Province of Quebec.2030 Notice to Interested Parties: 2022 Miscellaneous Notices: Algo Juniors Incorporated (Directors).2045 Club Richelieu Montréal Incorporé (Directors).2046 Club Richelieu Montréal Incorporé (By-Laws).2040 La Caisse Populaire Desjardins de Ste-Famille du Cap (Foundation).2040 La Fraternité Nationale Catholique du Transport de Quél>ec Inc.(Name changed).2044 Le Foyer Idéal (Foundation).- 2047 L'Entraide Immobilière Laurentienne (Foundation).2040 Les Utilités Domestiques, Limitée \u2014 Domestic Utilities Limited (Directors).2045 Le Syndicat National Catholique du Textile du Cap-de-la-Madeleine Inc.(Mason Spinning-Laurentian Silk) (Formation).2044 Nira Dress Inc.(Directors).2045 Realties Securities Limited (Distribution of the assets).2048 Samuel & Samuel Clothing Mfg.Inc.(Directors).2046 Syndicat National de l'Amiante de St-Rémi de Tingwick Inc.(Formation).2045 The British Rubber Company Limited (Directors).2047 The British Rubber Company of Canada Limited (Directors).2047 Charters \u2014 Surrender of: General Steamships Terminals Limited.2048 J.M.Lord et Cie Ltée\u2014J.M.Lord & Co.Ltd.2048 Realties Securities Limited.2048 DEPARTMENTAL NOTICES: Municipal Affairs: Trécesson, township of.2049 Agriculture: Dairy Industry: Order No.1-48D \u2014 Montreal.2050 Order No.48-Sp-VI \u2014 Eastern Townships.2049 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 17th, 191$, Vol.80, No.29 2071 Instruction publique: Chénier, munie, scolaire de.2051 Cookshire, munie, scolaire protestunte de.2051 Les Ecureuils, munie, scolaire de.2051 Ste-Flavie-de-Lcpage, munie, scolaire de.2051 Ste-Thérèse, munie, scolaire de la ville de.2050 Trésor: Assurances: Aluminium Fiduciaries Limited et al.2055 The Baltimore American Insurance Company of New York.2053 The City of New York Insurance Company .2053 The Franklin Fire Insurance Company of Philadelphia.2054 The Gibraltar Fire and Marine Insurance Company.2054 The Homestead Fire Insurance Company .\".2052 The National Liberty Insurance Company of America.2052 The New Brunswick Fire Insurance Company.2053 Erratum: Arrêté en conseil N° 972 \u2014 Industrie et métiers de la construction dans l'Ile de Montréal et la cité de Sala-berry-de-Valleyfield.Greffe de notaire: Ricard, Jean-Paul.Lettres patentes: Armor Automotive Distributors Inc.2024 Commodore Hotel & Yacht Club Inc.2025 Corporation de Placement Adanac \u2014 Adanac Investment Corporation.2025 Devon Investments Limited.2025 Eastern Townships Theatres, Inc.v.2026 Equity Agency Inc.2026 Gaspé Supplies Ltée \u2014 Gaspé Supplies Ltd.2027 General Instruments Ltd.2027 Hardware Merchants Limited.2027 J.A.Faguy & Sons Ltd.\u2014 J.-A.Faguy & Fils Ltée.2028 Lakeshore Motor Inc.2028 Les Liqueurs Elzéar Fortier Limitée.2028 M.G.M.Fashions Ltd.2029 Monarch Products Ltd.2029 Montreal Men's Press Club, Inc.\u2014 Cercle des Journalistes de Montréal, Inc.2029 Montrose Builders Inc.2030 Mount Royal Gun Club.2030 Nettoyeur Moderne Inc.\u2014 Modem Cleaner Inc.2031 QuebeQ Enterprises Ltd.2031 Quick Service Tuxis Limited.2031 Rochon Transport Inc.2032 Service de Lavage de 10 minutes Ltée \u2014 10 Minutes Car.Washing Ltd.2032 Sheedo Construction Co.Ltd.\u2014 Cie de Construction Sheedo Ltée.2032 S.M.Cycle Manufacturing Co.Ltd.2033 Sparkling Products Company Ltd.2 )33 Sparton Pants Limited.2033 Education: Chénier, school munie, of.2051 Cookshire, Protestant school munie.of.2051 Les Ecureuils, school munie, of.2051 Ste-Flavie-de-Lepage, school munie.of.2051 Ste-Thérèse, school munie, of the town of.2050 Treasury : Insurance: Aluminium Fiduciaries Limited et al.2055 The Baltimore American Insurance Company of New York.2053 The City of New York Insurance Company.2053 The franklin Fire Insurance Company of Philadelphia.2054 The Gibraltar Fire and Marine Insurance Company.2054 The Homestead Fire Insurance Company.2052 The National Liberty Insurance Company of America.2052 The New Brunswick Fire Insurance Company.2053 Erratum: 2056 2056 Letters Patent: Armor Automotive Distributors Inc.2024 Commodore Hotel & Yacht Club Inc.2025 Corporation de Placement Adanac \u2014 Adanac Investment Corporation.2025 Devon Investments Limited.2025 Eastern Townships Theatres, Inc.2026 Equity Agency Inc.2026 Gaspé Supplies Ltée \u2014 Gaspé Supplies Ltd.2027 General Instruments Ltd.2027 Hardware Merchants Limited.2027 J.A.Faguy & Sons Ltd.\u2014 J.A.Faguy & Fils Ltée.2028 Lakeshore Motor Inc.2028 Les Liqueurs Elzéar Fortier Limitée.2028 M.G.M.Fashions Ltd.2029 Monarch Products Ltd.2029 Montreal Men's Press Club, Inc.\u2014 Cercle des Journalistes de Montréal, Inc.2029 Montrose Builders Inc.2030 Mount Royal Gun Club.2030 Nettoyeur Moderne Inc.\u2014 Modem Cleaner Inc.2031 Quebec Enterprises Ltd.2031 Quick Service Taxis Limited.2031 Rochon Transport Inc.2032 Service de Lavage de 10 minutes Ltée \u2014 10 Minutes Car Washing Ltd.2032 Sheedo Construction Co.Ltd.\u2014 Cie de Construction Sheedo Ltée.2032 S.M.Cycle Manufacturing Co.Ltd.2033 Sparkling Products Company Ltd.2033 Sparton Pants Limited.2033 Order in Council No.972 \u2014 Construction industry and trades in the Island of Montreal and the city of Salaberry-2056 de-Valleyfield.Notarial Records: 2056 Ricard, Jean-Paul. 2072 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 juillet 191$, Tome 80, N° 29 Standard Mfg.lue.2034 Standard Mfg.Inc.2034 The British Rubber Company Limited 2050 The British Rubber Company Limited 2050 The Colonial Associates Ltd.2034 The Colonial Associates Ltd.2031 The Quebec Asbestos Mining Associa- The Quebec Asbestos Mining Association.3084 tion.2034 The Zimroh Choir of Montreal.2035 The Zimroh Choir of Montreal.2035 Trudeau, Runcourt & Benoist Inc.2035 Trudeau, Rancourt & Benoist lue.2035 United Dominion Mining Company United Dominion Mining Company Ltd.2035 Ltd.2035 W.-A.Lamontagne, Limitée.2030 W.-A.Lamontagne, Limitée.2030 Lettres patentes supplémentaires: Supplementary Letters Patent: Mailman Corporation Limited.2057 Mailman Corporation Limited.2057 Proclamations: Proclamations: Concernant l'érection de la paroisse de Concerning the erection of the parish La Redemption.2057 of La Rédemption.\u2022 ¦ 2057 Concernant l'érection de la paroisse de ' Concerning the erection of the parish Ste-Irène.2059 of Ste-Irène.2059 Concernant l'érection «le la paroisse de Concerning the erection of the parish St-François-,Xavicr-de-Viger.2060 of St-François-Xavicr-de-Yiger.2000 * Sikues sociaux: Head Offices: ( 0 J.A.Faguy & Sons Ltd.\u2014J.A.Faguy J.A.Faguy & Sons Ltd.\u2014J.A.Faguy & Fils Ltée.2062 & Fils Ltée.2002 Millstream Spoolwood Inc.2001 M il 1st ream Spoolwood Inc.2001 Monette Furs Inc.\u2014 Monette Fourru- Monette Furs Inc.\u2014 Monette Fourrures Inc.2062 résine.2002 Soumissions: Tenders: m Amos, commissaires d'écoles de.20G3 Amos, School Commissioners of.2063 St-Hubert, commissaires d'écoles de la St-Hubert, School Commissioners of the paroisse de.2062 parish of.2002 St-Jérôme, commissaires d'écoles de la St-Jérôme, School Commissioners of ville de.2064 the town of.2064 St-Maxime et SI-Josaphat de Longueuil, St-Maxime and St-Josaphat de Lon- commissaires d'écoles de.20G5 gueuil, School Commissioners of.2065 Vente, Loi de faillite: Sale, Bankruptcy Act: Rochon, J.-Roméo.2066 Rochon; J.-Roméo.2066 Vente par licitation: Sale by Licitation: Rioux, Onésime et al.2067 Rioux, Onésime et al.2067 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERLFFS' SALES: Arthabaska: Arthabaska: J.-S.Giroux Limitée vs Lauzière.2068 J.-S.Giroux Limitée vs Lauzière.206S Kamouraska: Kamouraska: Phmkett-Webster Lumber Company Plunkett-Webster Lumber Company Incorporated vs Rioux.2069 Incorporated vs Rioux.2069 Québec: Quebec: Auger et al vs Pre Fab Inc.et al.2069 Auger et al vs Pre Fab Inc.et al.2069 22703-o 22703-o Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur du Roi.King's Printer."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.