Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 15 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1949-10-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 81, N* 41 2373 Vol.81, No.41 \t\t \t\t¦¦I \t¦\t i r (Drapeau de la province de Québec, adopté pur arrêté eu conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flag of the Province of Quebec, adopted by Order in Council Number 72, bearing date January 21st, 1948) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 15 octobre 1949\tQuebec, Saturday, October 15th, 1949 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upbn reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme without préjudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter.3356 2374 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Hoi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demande! d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 206 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre ' o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.23879 \u20141-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so us to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion : 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.23879 \u20141-52 Lettres patentes Alphonse Turgeon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1949, constiluant en corporation: Alphonse Turgeon, courtier d'assurance.Dame Noella Vézina Turgeon, épouse séparée de biens de Alphonse Turgeon et dûment autorisée par ce dernier, et Robert Turgeon, administrateur, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire des affaires comme agents ou courtiers d'assurances dans toutes leurs spécialités, sujettes aux dispositions de la Loi des Assurances de Québec, sous le nom de \"Alphonse Turgeon Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 657, Chemin Ste-Foy, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-o L.DÉSILETS.Letters Patent Alphonse Turgeon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1949, incorporating: Alphonse Turgeon, insurance broker, Dame Noella Vézina Turgeon, wife separate as to property of Alphonse Turgeon and duly authorized by the latter, and Robert Turgeon, executive, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business of insurance agents or brokers in all lines of same, subject to the provisions of the Quebec Insurance Act, under the name of \"Alphonse Turgeon Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at 657 St.Foy Road, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October loth, 1949, Vol.81, No.41 2375 Audograph Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze septembre 1949, constituant en corporation: David A.Schwartz, avocat, «le la cité de West mount, Jack Schwartz, gérant de bureau, et Zoé (iaron, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous instruments, appareils, substances ou procédés se rapportant à la chimie, à la lumière, à l'optique, à l'électricité, ù l'acoustique, à la photographie et à la mécanique, sous le nom de \"Audograph Limited\", avec un capital de 850,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.I nombre des actionnaires de la compagnie est limité à vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25S89 L.DÉSILETS.Beaulac Assurance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze septembre 1949, constituant en corporation: Polydore Beaulac, agent d'assurance, J.Gaston Beaulac, commis, et Marie-Biaise Beaulac, comptable, tous de Shawinigan Falls, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants : Agir comme courtiers en assurances générales, sujet aux dispositions de la Loi des Assurances de la province de Québec, sous le nom de \"Beaulac Assurance Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawinigan Falls, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le quinze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-o L.DÉSILETS.Audograph Limited .Notice is hereby given that under Part lof the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1919, incorporating : David A.Schwartz, advocate, of the city of West mount, Juek Schwartz, office manager, and Zoé (iaron, secretary, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in any instruments, upparatus, substances or processes relating to chemistry, light, optics, electricity, acoustics, photography and mechanics, under the name of \"Audograph Limited\" with a capital stock of $50,000 dvided into 500 shares of $100 each.The number of the company's shareholders is limited to twenty (20).The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September.1949.L.DÉSILETS, 25889-0 Deputy Attorney General, Beaulac Assurance Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of September, 1949, incorporating: Polydore Beaulac, insurance agent, J.Gaston Beaulac, clerk, and Murie-Blaise Beuulac, accountant, all of Shawinigan Falls, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To act as general insurance brokers, subject to the provisions of the Quebec Insurance Act, under name of \"Beaulac Assurance Inc.\", with a capital stock of 840,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Shawinigan Falls, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889 Deputy Attorney General.Café Hi-Ho Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-goifverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize septembre 1949, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, avocat et conseil en loi du Roi, dé la cité de Westmount, Louis Abraham DeZwirek, avocat et conseil en loi du Roi, et Albert Gomberg, avocat, tous deux de la eité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme hôtelier, restaurateur et ^propriétaire de café, sous le nom de \"Café Hi-Ho Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Les pouvoirs accordés ne permettent pas les jeux d'argent, les jeux de hasard et les jeux mixtes de hasard et d'habileté et les paris illégaux.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L.DÉSILETS.Café Hi-Ho Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September, 1949, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, advocate and King's Counsel, of the city of Westmount, Louis Abraham DeZwirek, advocate and King's Counsel, and Albert Gomberg, advocate, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel-keeper and restaurant and café-keeper, under the name of \"Café Hi-Ho Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $100 each.The powers granted do not permit gambling games, games of chance and games of chance and skill mixed and illegal betting.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-0 Deputy Attorney General. 2876 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Qu/b c, lô octobre 1949, Tome 81, N° 41 Canadian Beef& Pork Supply Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant -gouverneur de la province de Québec, «les lettre! patentes en date du treize septembre 1049, constituant en corpora-ti«)ii: Paul Galt Micbaml.avocat, Georges-François Heidi avocat, et Louise Iléon, stéiutgrupbc.tous de la cité «le Montréal, «listrict jmlieiaire «le Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre, élever et faire le commerce d'animaux sur pie«l et bestiaux de toute «lcserip-tion; Manufacturer et faire le commerce de viandes «l'abattage et préparées} abattre des bestiaux et animaux «le toutes sortes, sous le nom «le \"Canadian Beef & Pork Supply Go.Ltd.\", avec un capital «le 140,000 «livisé en 400 actions de SI00 chacune.Le nombre «les actionnaires «le la compagnie sera limité à vingt (20).Le siège social «le la compagnie sera à Mont real, «listrict jmlieiaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize septembre 1919.L'Assistant-procureur général.25880 L.DÉSILETS.Canadian Cameo Chime Company Limited Avis est «humé «m'en vertu «le la première partie «le la I/oi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes en date du treize septembre 1949, constituant en corporation: Charles-Edouard Poirier, commis «le bureau, Adelaide McDerby et Ray momie Champagne, secrétaires, filles majeures, tous «les cité et «listrict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire les affaires «l'un commerce général qui consiste à manufacturer, entreprendre, négocier et faire le commerce de toutes sortes d'articles, objets et marchandises et d'articles électriques et / ou mécaniques, sous le nom «le \"Canadian Cameo Chime Company Limited\", avec un capital «le S10.0C0 divisé en 10,000 actions de SI chacune.Le siège s«x'ial tic la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L- DÉSILETS.City Hall Avenue Garage Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze septembre 1949, constituant en coloration: Hector Rergeron, mécanicien.Roland Rhéault, débosseur, et Aimé Chapdelaine, marchand, tous «les cité et «listrict jmlieiaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter ou opérer un commerce communément appelé \"Garage\", sous le nom de \"City Hall Avenue Garage Incorporated\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-o L.DÉSILETS.Canadian Beef & Pork Supply Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent huve been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth «l»v of September, 1949, incorporating: Paul Gall Michuiul, advocate, Georges-François Re id, advocate, ami Louise Héon, stenographer, all «>f the city of Montreal, judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To buy, sell, raise and «leal in live stock and cattle of every description; To manufactura and «lcal in slaughtered and dressed meats; to slaughter cattle and animals of all kinds, under the name of \"Canadian Beef & Pork Supply Co.I td.'\\ with a capital stock of $10,000 divided into 100 shares of $100 each.The number of shareholders of the Company shall be limited to twenty (20).The head office f the Attorney General, this thirteenth, duv of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-0 Deputy Attorney General, Canadian Cameo Chime Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent huve been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing n, gérant, Ions del cité et «listrict judiciaire «le Montreal pour les objets suivants: l'aire affaires comme manufacturiers et marchands d'accessoires élcctrituics, sous le nom «le \u2022Chantigny Electric Limitée\", avec inuapital «le si(10.01)0 divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au \\° j 111 est, rue Demontigny, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général le douze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25880-0 L.DÉSILETS.C.J.Broun & Company Limited Avis est.donné qu'en vertu «le la première par-lie de la Ijoi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes en «late du quinze septembre 1949, constituant en corporation: B.Nelson Holtham, avocat, et conseil en loi du Roi, Thomas Randall Edney, comptable agréé, Chas.A.White, Harry E.(irumly, avocats et Simone Sharpe, veuve, sténographe, tous de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de St-IVam;ois, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers d'épingles à linge et de tous articles faits de bois ou en partie de bois et métal ou fil de fer.sous le nom «le \"J.C.Brown & Company Limite*!\", avec un capital «le $70,000 divisé en 700 actions de S100 chacune.I/* nombre des actionnaires sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Danville, district judiciaire de St-François.Daté «lu bureau du Procureur général le quinze septembre 1949.L'Assistant -procu reu r général, 25889 L.DÉSILETS.Cliuntigny Electric Limitée Notice if hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth «lay of September, 1949, incorporating: Homère Chantigny, merchant, Géraldine Pomlrette Chantigny, wife separate as to property of sai«l Homère Chantigny ami duly authorised by him for the purposes hereof, ami Alban Mir«»n, manager, all of the city and judicial «listrict of Montreal, f«>r the following purposes: To carry on business as manufacturers of and deulers in electric accessories, umler the name of \"Cbantignv Electric Limitée\", with u capital stock of $100,000 divided into 1.000 shares of a pur value of $100 each.The head office of the compuny will be ut No.1111 Demontigny street Eust, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth «lav of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889 Deputy Attorney General.C.J.Brown & Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beuring date the fifteenth day of September.1949, incorporating: B.Nelson Holt-ham, advocate and King's Counsel, Thomas Randall Edney.chartered accountant, Chas.A.White.Harry E.Grumly, advocates, and Simone Sharpe, widow, stenographer, all of the city of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers of clothes pins and of all articles made of wood, or partly of wood and metal or wire, under the name of \"J.C.Brown & Company Limited\", with a capital stock of $70,000 divided into 700 shares of $100 each.The number of shareholders shall be limited to twenty.The head office of the company will be at Danville, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-0 Deputy Attorney General.Club Auto-Moto Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première par-tie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix septembre 1949, constituant en corporation: Emile Giroux, négociant «le Beauport, Rodrigue Ostiguy, Edouard Nadon, négociants, René Nolin, gérant, et Saint-Georges Côté, publiciste, ces quatre derniers de la cité de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Acquérir, construire, aménager des champs de courses et des amphithéâtres et tout ce qui s'y rapporte; Organiser, et exploiter des restaurants, des théâtres, sous le nom de \"Club Auto-Moto Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le «lix septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-0 L.DESILETS.Club Auto-Moto Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1949, incorporating: Emile Giroux, merchant, of Beauport, Rodrigue Ostiguy, Edouard Nadon, merchants, René Nolin, manager, and Saint-Georges Côté, publicist, these four latter of the city of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To acquire, build and equip race courses and amphitheatres and everything connected therewith: To organize and operate restaurants, theatres under the name of \"Club Auto-Moto Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889 Deputy Attorney General. 2378 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 Davis ami Wagner Garage and Service Station Limited Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix septembre 1949.constituant en corporation: Fred Davis, propriétaire de taxi.Dame Betty Indaig Davis, ménagère, é'pouse séparée de biens de Fred Davis et dûment autoriser par lui.Cari Wagner, voiturier, et Dame Sonia Tansky Wagner, ménagère, épouse séparer de biens de Cari Wagner et dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme garagistes et opérateurs d'un poste de service, sous le nom de \"Davis and Wagner Garage and Service Station Limited\", avec\" un capital de 810,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L.DESILETS.Grace Realty Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I/oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1949, constituant en corporation: Leon Crestohl, avocat et conseil en loi du Roi, Max Crestohl, avocat, tous deux de lacité d'Ou-tremont, Hilliard Ginsberg, avocat, de la cité de Montréal, Riva Berniee Shatsky.secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire, acquérir, disposer, exploiter, administrer, placer sur, et autrement faire le commerce d'immeubles, lots, propriétés et bâtisses, sous le nom de \"Grace Realty Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont réal.district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général.le huit septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L.DÉSILETS.Hakoah Country Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1949, constituant en corpora-ration: Max Crestohl, avocat, Riva Berniee Shatsky, secrétaire, tous deux de la cité d'Outre-mont, et Olyve Harrison, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce d'hôtel, auberge, restaurant, fournisseur de victuailles, pourvoyeur, tenancier de maison de pension et maison de chambres, sous le nom de \"Hakoah Country Club Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au Lac-à-la-Truite, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L.DÉSILETS.Davis and Wagner Garage and Service Station Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of September, 1949, incorporating: Fred Davis, taxi owner.Dame Betty Indaig Davis, housewife, wife separate as to property of Fred Davis and duly authorized by him, Carl Wagner, carter, and Dame Sonia Tansky Wagner, housewife, wife separate as to projierty of Carl Wagner and duly authorized by him, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business as garagists and service station operators, under the name of \"Davis and Wagner Garage and Service Station Limited\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-o Deputy Attorney General, Grace Realty Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1949.incorporating: Leon Crestohl, advocate and King's Counsel, Max Crestohl.advocate, both of the city of Outremont, Hilliard Ginsberg, advocate, of the city of Montreal, Riva Berniee Shatsky, secretary, spinster, of Outre -mont.and Olyve Harrison, secretary, spinster, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To construct, acquire, dispose of, operate, administrate, invest in and otherwise deal in real estate, lots, properties and buildings, under the name of \"Grace Realty Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-o Deputy Attorney General.Hakoah Country Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1949, incorporating: Max Crestohl, advocate, Riva Berniee Shatsky, secretary, both of the city of Outremont, and Olyve Harrison, secretary, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of hotel, inn, restaurant, victualers, careters, boarding house and lodging house, under the name of \"Hakoah Country Club Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Trout Lake, in the judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.81, No.41 2379 J.A.Roberge & Fils Limitée J.A.Roberge & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par-lie de lu Loi des eonipugnies de Québce, il a été accordé pur le Lieutenant-gouverneur de lu province de Québec des lettres patentes, en date «lu quilUM septembre 1919, constituant en corporation: .1.-Aristide Rolicrge, Luc Roberge, marchands de Mégantie, et Marc Roberge, marchand, de Saint-Georges de Hcuuce, tous du district judiciaire de Beauee, pour les objets suivants: Paire le commerce de tout genre de vêtements, chaussures, textiles, fourrures, marchandises sèches en général, sous le nom de \".LA.Roberge & Fils Limitée \" \u2014 \" J.A.Roberge & Sons Limited\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.I,e siège social de la compagnie sera en la ville de Mégantie, district judiciaire de Bcauce.Daté du bureau du Procureur général le quinze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-0 L.DÉSILETS.J.Beaudoin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première par-t ie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du treize septembre 1949, constituant en corporation: John Richard Hyde, Roland-Gérard Lefrancois, et Paul-Aldéric Ouimet, avocats, «les cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce «le lingerie et «le vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"J.Beau-doin Ltée\".\\je capital-actions de la compagnie est divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $5,000.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le treize septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 258S9-0 L.DÉSILETS.Katkin Business Equipment Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze septembre 1949, constituant en corporation: Ernest-J.Villeneuve, commerçant, Henri-Paul Lemay, avocat, et Ghislaine Gagné, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fournisseur de meubles et marchand d'effets de bureau, sous le nom de \"Katkin Business Equipment Co.\", avec un capital de $28,000 divisé en 600 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune, et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $25.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général le douze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-0 L.DÉSILETS.J.A.Roberge & Fils Limitée J.A.Roberge & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec ( 'ompauies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, licaring date the fifteenth day of September, 1949, incorporating: .1.Aristide Roberge.Luc Roberge, merchants, of Megantic, and Marc Roberge, merchant, of Saint-Georges de BeaiK'e, all of the judicial «listrict of Beauce.for the following purposes: To deal in all kinds of clothing, footwear, textiles, furs, dry gtxxls in general, under the name of \"J.A.Roberge & Fils Limitée\" \u2014 \"J.A.Roberge & Sons Limited\", with a capital stt>ek of $100,000 divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company will be in the town of Megantic, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of Septemlier, 1949.L.DÉSILETS, 25889 Deputy Attorney General.J.Beaudoin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September, 1949, incorporating: John Richard Hyde, Roland Gérard Lefrancois, and Paul Aldé-ric Ouimet, advocates, of the city ami judicial «listrict.of Montreal, for the following purposes: To f summer resident! of and persons owning immovable property in the municipality of this village of Metis Beach and vicinity, under the name of \"Metis Beach Community Association\".The amount to which the annual revenue from the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $1,000.The head office «>f the corporation will be at the Municipality of the Village of Metis Beach, judicial district of Rimouski.Dated at the «ifficc of the Attorney General, this ninth dav of September, 1040.L.DÉSILETS, 25889-o Deputy Attorney General.Roberval Wood Products Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Queliec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of September, 1949, incorporating: Louis Joseph Potvin, industrialist, Yvonne Guay Potvin, housewife, wife separate as to property by marriage contract of sai«l Louis Joseph Potvin, Eugene Parent, industralist.and Delila Grenon Parent, housewife, wife separate as to property by marriage contract of said Eugène Parent, all «>f Roberval, judicial district of Roberval, for tin-following purposes: To deal in lumber; to manufacture, make ami sell products wrought from wood, under the name of \"Roberval Wood Pro«lucts Company Ltd.\".with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Roberval, judicial district of Roberval.Date«l at the office of the Attorney General, this fifteenth day of September, 1949.L.DÉSILETS.25889 Deputy Attorney General.Senior Dress Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize septembre 1949, constituant en corporation: Lazar Tabachnik, Jacob Turowitz, marchands, et Samuel Stein, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme marchands, manufacturiers d'habits et vêtements de toute description pour hommes, femmes et enfants, fournitures de maison, bijouterie, menus objets, articles en cuir et tissus textiles, sous le nom de \"Senior Dress Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le nombre de ses actionnaires sera limité à vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Senior Dress Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September, 1949, incorporating: Lazar Tabach-nick, Jacob Turowitz, merchants, an«l Samuel Stein, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers, manufacturers, in men's women's and children's clothing, and wearing apparel of every description, household furnishings, jewellery, smallwares, leather goods and textile fabrics, under the name of \"Senior Dress Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each, and 400 preferred shares of a par value of $100 each.That the number of its shareholilers shall be limited to twenty (20).The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.81, No.41 2383 Daté du bureau du Procureur général, le treize septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 2.-.SS9 L.DÉSILETS.Service Tool Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première par-t if de la Loi des compagnies «le Quéliec, il a t''té a«v«>r«lé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu dix-neuf septembre 1949, constituant en corporu-tiun: Lucien Roux, CH., avocat, de West mount, Jean-Paul Verschelden, avocat, Lorraine Coté, Monique Le Marier, secrétaires, filles majeures, et Paul Lafontaine, huissier, tous quatre des cité et district ju«liciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et généralement faire le commerce «le toutes pièces mécani«iues.machinerie, sous le nom «le \"Service Tool Mfg.Co.Lt«l.\", avec un capital de $-10,000 divisé en 300 actions privilégiée! d'une valeur au pair «le $100 chacune et de 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $25 chacune.\\je siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le «lix-neuf septembre 1949.1 L'Assistant-procureur général.25889-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General this thirteenth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-0 Deputy Attorney General.Service Tool Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been [anted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beuring date the nineteenth day of September, 19 incorporating: Lucien Roux, K.C., advocate, of Westmount, Jean Paul Vers-chelden, advocate, Lorraine Côté, Monique Le Marier, secretaries, spinsters, and Paul Lafontaine, bailiff, all four «)f the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and «leal generally in mechanical parts and machinery, of all kinds, under the name of \"Service Tool Mfg.Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and 400 common shares of a par value of $25 each.The bead office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office, of the Attorney General, this nineteenth «lay of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889 Deputy Attorney General.St-Hyacinthe Transport (1949) Inc.P« St-llyacinthe Transport (1949) Inc.Avis est donné «m'en vertu «le la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- vince de Québec des lettres patentes, en «late du ince of Quebec, bearing date the thirteenth day of treize septembre 1949.constituant en corpora- September, 1949, incorporating: René Beaudry, tion: René Beaudry, gérant, Bernard Deslandes.manager, Bernard Deslandes, accountant, and comptable, et Emile Beaudry, garagiste, tous de Emile Beaudry, garage keeper, all of Saint Hya- Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint- cinthe, judicial district of Saint Hyacinthe, for Hyacinthe, pour les objets suivants: the following purposes: Exercer généralement le commerce de trans- To carry on generally the transport and cartage port, de camionnage, de service de livraison pour business and that of delivery service for the transie transport ou la livraison de marchandises, sous portât ion or delivery of merchandise, under the le nom de \"St-Hyacinthe Transport (1949) Inc.\", name of \"St-Hyacinthe Transport (1949) Inc.\", avec un capital «le $150,000 divisé en 1,500 actions with a capital stock of $150,000 divided into 1,500 de $100 chacune.shares of $100 each.Le siège social «le la compagnie sera à St-Hya- The head office of the company will be at St- cinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Hyacinthe, judicial district of Saint Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général le treize Dated at the office of the Attorney General, septembre 1949.\u2022 this thirteenth day of September, 1949.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 25889-0 ' L.DÉSILETS.25889 Deputy Attorney General.St-Jean-Baptiste Boulevard Taxi Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, des lettres patentes, en date du douze septembre 1949, constituant en corporation sans capital-actions: Roland David, Paul Léonard et Laurent Charbon-neau, tous propriétaires de taxis, de Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Voir au maintien des justes droits des propriétaires de taxis et conserver l'harmonie entre les intéressés dans les différents moyens de transport, sous le nom de \"St-Jean-Baptiste Boulevard Taxi Association\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.St-Jean-Baptiste Boulevard Taxi Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1949, to incorporate as a corporation without share capital: Roland David, Paul Léonard and Laurent Charbonneau, all taxi owners, of Pointe-aux-Trembles, judicial district of Montreal, for the following purposes: To see to the maintenance of the just rights of taxi owners and to conserve harmony between the interested parties in the various means of transportation, under the name of \"St-Jean-Baptiste Boulevard Taxi Association\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000. 2384 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 octobre 191,9, Tome 81, N° kl Ia' siège social de la corporation sera en la ville «le Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le douze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889-0 L.DÉSILETS.Superior Iron & Metal Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix septembre 1949, constituant en corporation: Samuel E.Sehwisberg, Cit., Cyril E.Schwis-berg, avocats, de la cité d'Outremont, et Sonya Schneyer, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district jmliciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre, négocier et faire le commerce «le toutes sortes «le métaux et minéraux, y compris la ferraille et rebuts de métaux; Exercer le commerce comme fontleurs et raffi-neurs et celui «le fonderies de fer, fomleries de bronze, lamineries, moulins pour la fabrication de plaques, ateliers «le mécanique et usines d'avions, sous le nom «le \"Superior Iron & Metal Co.Lt«l.\", avec un capital de $40.000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le dix septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L.DÉSILETS.Twin Mountain Home Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf septembre 1949, constituant en corporation: sans capital-actions: Dr YV.G.Krauser, médecin, de ville Mont-Royal, Mary T.Reynolds, diététicienne, de St-Laurent, James Mortimer Burnett, gérant de publicité et Kenneth Blake O'Brien, distributeur, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Fournir, entretenir et diriger des camps d'été pour garçons et filles, sous le nom de \"Twin Mountain Home\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25889 L.DÉSILETS.Siège social Hatch craft Ltd.Avis est par les présentes donné que \"Hatch-craft Ltd.\" qui fut incorporé en vertu de lettres patentes accordées le 30 mai 1949 a établi son bureau chef à 54 rue St-Vallier, Québec, P.Q.Québec, ce 6 octobre 1949.Le Secrétaire, 25901-O JACQUES de BILLY.The head office of the corporation will be in Town of Pointe-aux-Trembles, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September, 194!).L.DÉSILETS.25889 Deputy Attorney General.Superior Iron & Metal Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quel>ec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of Sep-tomber, 19-19, incorporating: Samuel E.Schwis-berg, K.C., Cyril E.Sehwisberg, advocates, of the city of Outremont, and Sonya Schneyer, secretary, spinster, of the city of Montreal, all in the judicial «listrict of Montreal, for the following purposes; To buy, sell and deal in and deal with all kinds of metals and minerals including scrap iron and scrap metals; To carry on the business of smelters and refiners, of iron foundries, brass foundries, rolling mills, plating mills, machine shops and aircraft works, under the name of \"Superior Iron & Metal Co.Lt«l.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this tenth «lav of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-o Deputy Attorney General.Twin Mountain Home Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day «»f September, 1949, incorporating: without share capital: Dr W.G.Krauser, physician, of tin-Town of Mount Royal.Mary T.Reynolds, diete-citian, of St Laurent, James Mortimer Burnett, advertising manager, and Kenneth Blake O'Briei.distributor, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To provide,' maintain and conduct summer camps for boys and girls, under the name of \"Twin Mountain Home\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of September, 1949.L.DÉSILETS, 25889-o Deputy Attorney General.Head Office Hatch craft Ltd.Notice is hereby given that \"Hatchcraft Ltd.\", incorporated by letters patent granted on May 30, 1949, has established its head office at 54 St-Vallier Street, Quebec, P.Q.Quebec, October 6, 1949.JACQUES de BILLY, 25901 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.SI, No.41 2385 Vente pour taxes Sale for Taxes AVIS DE VENTE D'IMMEUBLES NOTICE OF SALE OF IMMOVABLES Avis public est par les présentes donné que Iff propriétés immobilières ci-après mentionnées et p us spécialement désignées dans une cédule déposée dans mon bureau, le 26e jour de sep-tembie 1949, seront vendues par moi, à mon l.ureau, (Uns la Cité de Montréal, le JEUDI, iREMIER jour de DÉCEMBRE, 1949, à I IX heure- du matin, à raison d'une réclama-t i( n de la Cité de Montréal, pour taxes et con-I ributic ns foncières annuelles ou spéciales ou p; ur arrérages tie taxes consolidées.Public notice is hereby given that the immovable properties hereinafter mentioned, and more particularly described in a schedule filed in my office, on the 26th day of September 1949, will be sold by me, at my office, in the City of Montreal, on THURSDAY, the FIRST day of DECEMBER, 1949, at TEN o'clock in the forenoon, upon claim by the City of Montreal for annual or special real estate taxes and assessments or for arrears of consolidated taxes.0 o 1 I a J\tDivision d'enregistrement Registration Division\tCadastre\tSubdivision\tN° Civique, Rue Civic No., Street\tNom du propriétaire Name of proprietor\tS S?1 8» Jl 11 120099\tSt.Ann's Ward.\tp!617\t\t110-12 Duke .\tWilma E.MacDonald, épse de-wife of Thomas Albert Gray et al.\t30 03 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.120216 Quartier Ste-Anne.St.Ann's Ward.pi 624 147 Nazareth.Wilma E.MacDonald, épse-de-wife of Thomas Albert Gray I Hal.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.448.85 120219Quartier Ste-Anne.St.Ann's Ward.pi 628 117-21 Nazareth .Wilma E.MacDonald, épse-de-wife of Thomas Albert Gray etal.268.75 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.120609 120736 Quartier Ste-Anne.St.Ann's Ward.Quartier Ste-Anne.St.Ann's Ward.pi 170 pl617 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des pl628 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des 1726-32 Notre-Dame O.-W.Laura Beauchamp, we de-wid.of Edmond Sawyer.arrérages de taxes.120738 831-35 Wellington Wilma E.MacDonald, épse de-100 Duke.wife of Thomas Albert Gray etal .796.88 Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.1,105.92 Quartier Ste-Anne.St.Ann's Ward.arrérages de taxes.849-65 Wellington Wilma E.MacDonald, épse de 115 Nazareth.wife of Thomas Albert Gray etal .1,422.07 Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.176.74 120980 Par.de-of Montreal .3034.1974-80 Ri- Quartier Ste-Anne.963.chardson.ISt.Ann's Ward.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.Johan Kulccycky et al 121469 131041 Quartier Ste-Anne.St.Ann's Ward.377.378.465.pll 1226-34 Forfar.1454 St-Antoine .Frank Yakimowsky 310.27 Quartier St-Antoine.St.Antoine Ward.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.Yvonne Oui met, we de-wid.of Lucien Trempe.251.61 191049 Quartier St-Louis St.Louis Ward.570.89-93 DeMon-tigny E.Rose de Lima Corbeil.we de-wid.of Zéphirin Normandin etal.250.83 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.191050 Quartier St-Louis St.Louis Ward.569.81-85 De Monti-gny E.Rose de Lima Corbeil, we de-wid.of Zéphirin Normandin etal.334.44 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.211269'ouartier Ste-Marie.Ip900 .1.11469-75 Logan, .|D.-A.-Gérard Jutras.:.340 02 I St.Mary's Ward.Ill I I 2386 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 Quartier Sto-Marie.8t.Mary's Ward.220313 Quartier Sto-Marie.636.12.13.14.1551-59 Ave Marie-Ange Charpentier, épse Papineau.de-wife of Eugène Lapointe.1,436.00 1815-19 De Montigny E.Sujet & la créance privilégiée do la consolidation des Subject to tho privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrearn.220545 220580 Quartier Ste-Marie.St.Mary's Ward.Quartier Ste-Marie.St.Mary's Ward.636 .\t11.\t1821-26 De\tMarie-Anne Charpentier, épse de-wife of Eugène Lapointe .\t \t\tMontigny E.\t\t266.40 615.\t11.\t1868 De Montigny E.1470 Cartier.\tMarie-Anne Charpentier, épse de-wife of Eugène Lapointe .\t518 95 Sujet à la créance privilégiée do la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.220582.Quartier Ste-Marie.I St.Mary's Ward.|Marie-Anne Charpentier, épse i L 381.26 636.5.6.1822-28 De Montigny E.Idc-wife of Eugène Lapointe .Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of tho consolidation of tax arrears.arrérages de taxes.240240 Par.Montreal 240266 240326 240842 241434 Par.Montréal Par.Montréal Par.Montréal Par.Montréal 2604 2739.p2626 p2626 p2625 3238.3383.3384 5,6.4,3.2736-48 Centre 2761-67 Cha-teauguay.2506-16 Centre 2776-86 Cha- teauguay.1121-25 D'Ar- genson.Charon.2362-72 Knox Be St.Realties Corporation Bo St.Realties Corporation Be St.Realties Corporation Mabel Wilson, we de-wid.of Thomas Armstrong.Charles Robin.708.31 848 64 701 14 35.84 225.21 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.250607 281603 301032 301268 Par.Montréal Quartier St-Louis St.Louis Ward.Village Hochelaga.Village Hochelaga.513.512.917.148 .148.8-3,p7-3, 8-2.p7-2, 8-l.p7-l.2665.2582.2251-6la Workman.170-176 Roy.3792-94 Ave de l'Hôtel de Ville.Charlotte Chrétien, vve de-wid.of Fortunat Lacombe.Ave Gascon Hogan.Be St.Realties Corporation .J.-Napoléon Préfontaine Thomas Hill, Sr.351.17 592.78 48.92 68.23 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.arrérages de taxes.301440\t\t148.\t2293.310867\t\t29.\t455-1.455-2-1.330149\t\t18.\t1025, pl026.351332\tPar.Longue Pointe .\t17.\t94.363433\tPar.Longue Pointe .\t28.\t754.354059\tPar.Longue Pointe .\t29.\t143 1 364060\tPar.Longue Pointe .\t29.31.\t1439 17.364716\tPar.Longue Pointe .\t28.\t189.360813\tPar.Longue Pointe .\t326.\t10-30.360838\tPar.Longue Pointe .\t326.\t10-57.360840\tPar.Longue Pointe .\t326.\t10-60 .10-59.2365-69 Montgomery.2189-93 Davidson.3475-79 Ave d'Orléans.3920-30 Rachel E.45e Ave.Bossuet Cadillac Cadillac Ontario Est Lyall Hays Ave 570 Hays Ave L.-N.-Raoul Dubuc .Patrick Tanguay.Mike Skwarka.Edwin Ernest Ordridge Alex Miller et al.Olivine Thesan .Olivine Thesan .Suce-Est.Maria Pepin, we de wid.of Augustin Tétreault .Alexandre Morin Julien Vincent Florida Proulx, épse de-wife of Albert Vincent.223.17 350.82 1,468.75 3.77 3.46 2.69 2.84 16.06 16.63 39.40 120.63 Sujet à la créance privilégiéo de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de Saxes.366135 366804 372041 372042 374383 374384 of tax arrears.Par.Longue Pointe Par.Longue Pointe Par.Longue Pointe Par.Longue Pointe Par.Longue Pointe Par.Longue Pointe 398.398.399.399.407.407.692.671.717.716.114.113.Marie Antoinette 5160 Baldwin 8694 Sherbrooke Est.Sherbrooke Est .Fletcher Ave Fletcher Ave Royden Al vin Smith .Mlle Réjeanne Lauson Douglas D.Gilbert.Douglas D.Gilbert James Morgan James Morgan 10.40 44.87 81.43 51.72 11.06 11.06 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.81, No.41 2387 374385 Par.Longue Pointe 37438011'ar.Longue Pointe 41220o!Par.Montréal.421492 Par.Montréal.421091 ,Par.Montréal 431190 Par.Montréal 431502 Par.I 433159: Par.Montréal Montréal 143085\tPar.\tMontréal 443080\tPar.\tMontréul 444203\tPar.\tMontréal 445875\tPar.\tMontréal 452475\tPar.\tMontréal 452470\tPar.\tMontréal 452477\tPar.\tMontréal 452478\tPar.\tMontréal 453041\tPur.\tMontréal 454119\tPar.\tMontréal 454150\tPar.\tMontréal 454151\tPar.\tM ontréal 454297\tPar.\tMontréal 454298 Par.Montréal 47087 11 Village Côte des Neiges Sujet à la créance privilégiée de la arrérages de taxes., 407.\t112.407.\t111.3017.\t475.1582\t1.2.3.4.1585.\t1.2.3.1913.\t73.05.\t732.05.\t310.184.\tp568 .162.\t412.162.\t413.156.\tP43 152.\t626.142.\t137.142.\t136.142.\t135.142.\t134.181.\t28-3.29-3 118-1 117-1.156.\tP185 .156.\tP186 .156.\tP187 .147.\tP92 .147.\tP93 .58.\tE-2-1 .Fletcher Ave Fletcher Ave 6044 Dumas.4351-83 St- Jacques O.-W.709 Laçasse.4291-95 St-Ambroise.5460-62 Ave Bourret.Ave Clanranald.3551-53 Boul.Décarie.Kensington Ave .Kensington Ave .Benny Ave.Park Row East.West more.Westmore.Westmore.Westmore.James Morgan James Morgan Henri Laurin .Z.Maxime Aumont et al Emma Brien dit Desrochers, we de-wid.of Charles-Arthur Lépine.R.-G.Lord Limitée R.-G.Lord Limitée Nicholas Sclavounakis alias Nicholas Nakis .5317-15 Western Ave.Ave N.-D.De Grâce.Ave N.-D.De Grâce.Ave N.-D.De Grâte.Monkland Ave Monkland Ave Ave Soissons Alexander Ellison.Alexander Ellison.John Robert Mcintosh Gordon S.Fletcher.J.-Alphonse Desroches J.-Alphonse Desroches J.-Alphonse Desroches J.-Alphonse Desroches Victor Dupuis .Builders and Realtors Limited.Builders and Realtors Limited.Builders and Realtors Limited.Builders and Realtors Limited.Builders and Realtors Limited.11.05 11.04 78.40 2.077.08 270.34 476.95 111 18 464.80 69 08 69.07 49.53 91 63 10.80 10.86 10.86 10.86 158.94 119.81 102.50 102.50 133.38 108.32 Amelia Deguire, we de-wid.of Edouard Cardinal, etal .2,146.91 consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.470S72 Village Côte des Neiges 68.Sujet à la créance privilégiée de la arrérages de taxes.E-l.Ave Soissons consolidation des Amelia Deguire, we de-wid.of Edouard Cardinal, etal .12,240.40 Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.470897 Village Côte des Neiges 58.E-8 Northmount Ave Sujet à la créance privilégiée de la arrérages de taxes.Amelia Deguire, we de-wid.of Edouard Cardinal, etal .13,644.06 consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.472135\tVillage Côte des Neiges\t152.\tp29-2.500295\tVillage St-Jean-Baptiste Village St-Jean-Baptiste\tpl72\t 500455\t\t15.\t1203.531143\tVillage Côte St-Louis .\t328.\t615, 614, 613, 612, 611.610, 609, 385, 384, 383, 382.531370\tVillage Côte St-Louis .\t329.\t133.531371\tVillage Côte St-Louis .\t329.\t132.540920\tVillage Côte St-Louis .Village Côte St-Louis .Village Côte Visitation.\t336\t5.640921\t\t336\t4.540951\t\t163.\tp85.Grosvenor Ave 4818 Ds Bullion 4297-95 Ave de l'Hôtel de Ville.4831-01 Boyer .1017-19A Gilford 4544-46 Brébeuf 4548-52 Brébeu Ave Papineau Ave Papineau 4371-73 Ave Papineau.1809-17 Ruelle Morel.J.Napoléon Préfontaine J.Raoul Larivée Antoni Pohoda .Paul Aimé Lanoue Roland Beaudry Roland Beaudry J.Achille Francceur J.Achille Francceur Eugène Hardy 62.90 184.12 21.37 1,264.15 169.17 260.83 100.34 100.33 444.01 2388 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 641188\tVillage Côte Visitation\t163.\t242, p241 .641192\tVillage Côte Visitation\t163.\t223.641290\tVillage Côte Visitation\t101.\t704.641890\tVillage Côte Visitation.\t12____\tp288 .560798\tVillage Côte St-Louis.\t11.\tp809 ,, 500919\tVillago Côte St-Louis.\t11.\tp795 .4715-09 Cartier .4085-83 Cartier .5438-48 Chabot .4019-17 Ave des Erables.5041-45 Ave de l'Esplanade.5702-04 Waverly.Henri Henuud .Henri Renaud .Dominique A.G.Jutras .Rosa Anna Buyer, vve de-wid.of J.Euclide Côté.Be St.Realties Corporation Alexandre Moquin .352.82 204.33 362.31 223 69 518 40 680.98 Sujet à la créance privilégiée de la consolidât on des Subject to the privi'oged debt of the comolidatiou arrérages de taxes.of tax arrears.580103 580744 581490 5S2107 Par.St-Laurent.Par.St-Laurent.Par.St-Laurent.Par.St-Laurent.633.634.636.637.372.250.111.1324.McEachran Ave Stuart Ave.7034 Ave Outromont.L.-Alfred Guyot Antonio Gracia Stella Seymour, vve de-wid.of A.Edward Botham da1.René Lu vote.16.14 22.3J 78.77 48.31 Sujet à la créance privilégiée de la arrérages de taxes.5841231 Village Côte St-Louis.jl 1.Sujet à la créance privilégiée de la arrérages de taxes.S440 Bloomfield Ave.consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.Jl565.|7117 Waverly .Udrien Rivet .I 158.08 consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.584124\tVillage Côte St-Louis.\t11____\t1566.584125\tVillage Côte St-Louis.\t11.\t1507.584126\tVillage Côte St-Louis.\t11.\t1508.684351\tVillage Côte St-Louis.\t11.\tPI 120 .584374\tVillage Côte St-Louis.\t11.\tPI 1*1 .684375\tVillage Côte St-Louis.\t11.\tPI 151 .584376\tVillage Côte St-Louis.\t11.\tPI152 .584484\tVillage Côte St-Louis.\t11.\tP1255 .P1254.Waverly Waverly Waverly 0307-69 Clark 0541-43 Clark 6545 Clark 0551 Clark 6786-84 Boul.St-Laurent.Nathan Morganstein Nathan Morganstein Nathan Morganstein René-Laurier Guilbault Crate and Box Mfg Corp.Crate and Box Mfg Corp.Crate and Box Mfg Corp.Jean Seller .71.07 71.07 36.48 181.90 305.95 230.93 82.86 331.20 Sujet à la créance privilégiée de !a arrérages de taxes.585249|villago Côte St-Louis.JlO.686672 Par.St-Laurent.638.consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.610666 611357 611787 612468 Village Côte St-Louis.Village Côte St-Louis.Village Côte St-Louis.Village Côte St-Louis.1544.'6605-71 Alma____ 1453.Ave Querbes P699 592.P607.346.345.6006-08 Ave Chateaubriand.6331-29 St-André 6665 Ave Ch.Colomb.207.Bat.-Bldg Chambord.208.5877 De Nor- Patrick Heagerty .311.25 manville.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.Paul-Aimé Lanoue James Patrick Clark.L.-Martin Brasseur Mariette Frégault, épse de-wife of G.Boulanger Rousseau.Alice Guertin, épse de-wife of Léo-Paul Rouleau 431.08 12.82 273.20 216.64 438.48 631622 Village Côte St-Louis.3.73.II.-Laurier Guilbault 280.24 .6523-17 Marquette.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.650506 650722 650723 651350 Village Côte Visitation.Par.Sault au Récollet .Par.Sault au Récollet .Par.Sault au Récollet .208.476.476.476.380, 381 577.570.pl69 .of tax arrears.6276 Louis Hemon Louis Ileraon Louis llenvm Evelina Danis, épse de-wife of Donat Sareault etal .Rérçino Wauthier, vve de-wid.of Nestor Wallot .Régine Wauthier, vve de-wid< of Nestor Wallot .Jeanne Gonthier, épse de-wife of R.Laurier Guilbault .316.04 9.48 9.4S 303.61 7071-75 Des Boons.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.651351 Par.Sault au Récollet .476.pl69 168.Jeanne Gonthier, épse de-wife of R.Laurier Guilbault .7065 Des Ecores .682.22 Sujet à 1a créance privilégiée de la consolidation de» Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes of tax arrears. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 16th, 19&, Vol.81.No.+1 2389 661811\tVillage Coll- Visitation\t183.\t122.BolOffl B01067\tVillage < '«'>'«' Visitation Village Côte Visitation\t\t \t\t194.\t60.664966\tVillage Côte Visitation.\t188.\t1275.664247\tVillage Côte Visitation.\t188.\t1274.671*07\tVillage Côte Visitation.\t192.\t82.071978\tVillage Côte Visitation.\t199.\t902.Ave CliarlcmuKiio Hdul.Pie IX Houl.Pie IX 4()i('-ine Ave.4Oil-1ne Ave.Belleehas.se.St-Zotique E.I'.Armand Richard George Cuchureau (Jeorge Cuchureau J.Stanley Downs J.Stanley Downs Kmmanuel Grenier Suce.-Est.Zorela Kohitaille, épse de-wifo of J.E use be Voyer 15 38 18.0!) 18,09 4.04 4.05 79.79 8.39 Sujet à la créance privil'giée de la consolidation dos Subject to the privileged debt of the consolidation kireragsa de taxes.of tax arrears.OS 14971 Par.Sault au Récollet .\t490.\t495.0M 498! Par.Sault au Récollet .\t490.\t494.\t2630.\t471.\t\t St-André Bruno Dupont 8121 St-André .Bruno Dupont J.Roland St-Onge 8131 Ave Des Belges.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation 37.76 62.38 89.75 .hit'rages de taxes.of tax arrears.C86228 686994 - 98369 i 98268 i>93254 < 193265 698266 Par.St-Laurent.Par.St-Laurent.Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet r,'j3257 Par.Sault au Récollet \u2022 193259 696646 686881 71(1930 710981 716466 7l'0525 720526 Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.St-Laurent.2628.\t14.2630.\t629.240.\t51.240.\t52.240.\t53.240.\t54.240.\t56.240.\t56.240.\t68.224.\t638.Par.St-Laurent.Par.Sault au Récollot Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollct 721K94 Par.Sault au Récollet 721895 730000 730001 740694 Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet Par.Sault au Récollet 217.350.350., 133.134'., 134., 164.164.262.262.298.141.968.967.384.871.870.1332.1331.665.666.Lajeunesse 8482 St-Hubert Lajeunesse .Lajeunesse .Lajeunesse .Lajeunesse .Lajeunesse .Lajeunesse .Lajeunesse .9795 Boul.Olympia.9748 Ave Hamel Stuart Ave.Nicola Frascarelli Gérard Labbé .Arthur Tamburini.Arthur Tamburini., Arthur Tamburini., Arthur Tamburini.Arthur Tamburini.Arthur Tamburini.Arthur Tamburini.Raoul Laurent Jette Ernest Boisvert Stuart Ave Iberville Rancourt .Ran court .Ave De Lorimier .Ave De Lorimier .Boul.St-Laurent.Boul.St-Laurent.Rose de Lima Corbeil.we de-wid.of Zephirin Normandin .Rose de Lima Corbeil, we de-wid.of Zephirin Normandin .La Cie Provinciale d'immeuble Limitée .Douglas Gilbert.Douglas Gilbert.Isabella Rooney Isabella Rooney Laura Bcauchamp, vve de-wid.of Edmond Sawyer .Laura Beauchamp.vve de-wid.of Edmond Sawyer .Marie Louise Laurin, épse de-wife of Alcide Desjardins.54.77 111.48 66.46 66.45 66.46 66.45 66.46 60.34 60.36 40.31 80.25 3.23 3.22 1.86 3.71 3.71 9.70 9.38 37.66 37.66 169.03 1479 Boul.Gouin O.-W.Sujet :\\ la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages da taxes.of tax arrears.741759 Par.Sault au Récollot .p308 Ferme-Farm De Louisbourg.Cremasie Realty Ltd 2,703.67 Conformément au premier alinéa de l'article In accordance with the 1st paragraph of Art.401 de la Charte de la Cité de Montréal, tel 401 of the Charter of the City of Montreal, as qu'amendé par la loi 1 (ieorge VI, chap.103, amended by the Act 1 George VI, chap.103, sec.62, un dépôt de 10% du montant de l'éva- section 62, a deposit of 10% of the amount of luation municipale inscrite au rôle en vigueur the municipal valuation entered on the roll in lors de cette vente, sera exigible du plus haut force at the time of the sale, shall be exacted enchérisseur avant l'adjudication finale.from the highest bidder, before final adjudication.Le Shérif, L.-P.CAISSE, L.-P.CAISSE.Sheriff.Bureau du shérif, Sheriff's Office, Montréal, le 13 octobre 1949.25918-o Montreal, October 13th, 1949.25918-o 2390 GAZETTE OFFICIELLE DE QVEllEC, Québec.1Ù octobre 1949, Tome 81, N* 41 Avis divers LOI du régime des eaux courantes Chapitre 98, S.K.Q.1941 FORMULE 1 1.\u2014 (Articles) Avis de lu demande des plans et devis.Avis est donné au public, conformément à l'article 8 de la Loi du régime des eaux courantes, que la Corporation de la Ville de Mégantie, dans le comté de Frontenac, Que., se propose de demander l'autorisation d'installer une turbine génératrice de 2250 II.1*.Cette turbine génératrice sera installée dans une nouvelle usine qui sera construite sur la rivière Chaudière, entre les contours Spauldiug et (iayhurst.au site connu sous le nom de site (iayhurst.En plus de l'usine, les travaux comprendront la construction d'un barrage en terre d'une hauteur de 06 pieds, à travers la rivière, avec déversoir en béton muni de trois vannes de contrôle en acier.Avis de plus est donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant l'emplacement choisi pour la construction de ces ouvrages, et le terrain affecté à été transmise au ministre des terres et forêts, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la division d'enregistrement du comté de Frontenac, à Lac Mégantie, P.Q.La demande contenue dans la requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Sherbrooke, P.Q., le 19 septembre 1949.Les Ingénieurs Professionnels pour la Corporation de la ville de Mégantie, Crkpeau, Cote & Lkmieux.25779-38-4-0 Avis est donné qu'à une assemblée générale spéciale des membres de l'association \"The Arvi-da Athletic Association (A.A.A.)\", tenue 'à Arvida le 29 septembre 1949, le nom de ladite asso\"iation a été.par une resolution dûment adoptée à cette fin, changé en celui de \"The Arvida Athletic & Recreation Association (A.A.R.A.)\", et ce conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi «les clubs de récréation (S.R.Q.1941, chapitre 304).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 8 octobre 1949.Le Sous-secrétaire de la Province, 25895 JEAN BRUCHÊSI.Domestic Electric Limited Je, soussigné, secrétaire de la compagnie \"Domestic Electric\", certifie par les présentes que ce qui suit est un sommaire du règlement \"A\" passé par les directeurs de ladite compagnie, le 17 mai 1949.Que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf pour fins de ventilation de ses affaires, qu'elle n'a aucune dette ni obligations et qu'elle a décrété la distribution de son actif en espèces entre les actionnaires pro-rata au nombre d'actions détenues par eux, respectivement.Granby, ce 17 mai 1949.Domestic Electric Limited, Le Secrétaire, 25919-0 FRANCES-A.DUNN.Miscellaneous Notices Water Course Act Chap.98, R.S.Q.1941, FORM 1 1 \u2014 (Section 8).Application and Notice of Deposit of Plans and Specifications.Public notice is hereby given in accordance witli section 8 of the VYater Course Act, that the Corporation of the Town of Megantic, in the County of Frontenac, Que., intends to apply for authorisation to install one water-wheel and generator of a capacity of 2250 H.P.This generating unit will be installed in a new power house to be erected on Chaudière River, between the Townships of Spauldiug ami (iayhurst, at the Bite known as \"Gayhurst Site\".Resides the power house, the project will include the construction of an earth dam of 66 feet in height, across said river of concrete spillway equipped with three control steel gates.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications of such work, showing the site chosen for the construction thereof and the land affected has been forwarded to the Minister of Lands and Forest, and that a duplicate of such plan and specifications has been deposited ut the registry office of the registration division of Frontenac, at Lake Megantic, P.Q.The application contained in the petition will be taken into consideration on or after the day following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Sherbrooke, P.Q., September 19th, 1949.Crkpeau, Cote & Lemieux, Professional Engineers for the Corporation of the Town of Megantic.25779-38-4-0 Notice is hereby given that, at a special general meeting of the members of the association \"The Arvida Athletic Association (A.A.A.)\" held at Arvida on September 29, 1949.the name of the said association was, by a resolution duly adopted for such purpose, changed to that of \"The Arvida Athletic & Recreation Association (A.A.R.A.)\", and such in conformity with the provisions of section 4 of the Amusement Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 304).Given at the office of the Provincial Secretarv, Octol>cr 8, 1949.JEAN BRUCHÊSI, 25895-o Under Secretary of the Province.Domestic Electric Limited I, the undersigned, secretary of \"Domestic Electric Limited\", do hereby certify that the following is a summary of by-law \"A\", passed by the directors of the said company, on the 17th day of May 1949.That the company has ceased to carry on business, except for the purpose of winding up its affairs, has no debts or obligations, and has ordered the distribution of the assets in specie among the shareholders pro rata according to their several holdings of stock.Dated at Granby, this 17th day of May 1949.Domestic Electric Limited, FRANCES-A.DUNN, 25919-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 16th, 1949, Vol.81, No.41 2391 Romaine Riveii Railway Company Règlement N° 4 Augmentant le nombre des directeurs de, quatre à sept Qu'il soit décrété par les directeurs de la compagnie \"Romaine River Railway Company\" COfflffli un règlement de ladite compagnie ce qui Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de quatre à sept, de manière à ce que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de sept directeurs.Je, le soussigné, secrétaire de la compagnie \"Romaine River Railway Company\", certifie, par les présentes, que le règlement ci-dessus a été passé par les directeurs en date du 10 août 1949, et qu'il a été confirmé à l'unanimité par tous les actionnaires à une assemblée spéciale tenue à la date sus-mentionnée.Le Secrétaire.2sm V.A.de HILLY.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Breakeyville\", en date du 12 septembre 1949, dont le siège social est situé à Ste-Hélène de Breakeyville, comté de Lévis, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 26 septembre 1949.Le Sous-secrétaire de la Province, 25890-o JEAN BRUCHÊSI.L'Association Canadienne d'Urbanisme, \u2014 Division de la Province de Québec The Community Planning Association of Canada \u2014 Quebec Provincial Division Extrait des règlements de la corporation ci-haut mentionnée concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs de quatre à dix: \"IV \u2014 Conseil d'administration et Comité exécutif (de la division) \u2014 Le Conseil d'administration de dix membres de la Division provinciale sera composé du président, de deux vice-présidents, avec un substitut élu pour chacun, du secrétaire-trésorier et d'un délégué de chacune des sections actuelles et futures de la Division provinciale.Le Vice-président, 2589 l-o EMILE NADEAU, M.D.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 5 octobre 1949, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Le Syndicat National Catholique des Employés de l'Industrie du Cuir et de la Chaussure des Trois-Rivières Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 8 octobre 1949.Le Sous-secrétaire de la Province, 25893-o JEAN BRUCHÊSI.Romaine River Railway Company By-lMw No.4 Increasing the number of directors from four to seven.Be it enacted by the directors of \"Romaine River Ruilway Company\" as a By-law of the suid Company as follows: The number of directors of the Company be and the same is hereby increased from four to seven so that the board of Directors of the Company shall hereafter l>e composed of seven directors.I, the undersigned.Secretary of \"Romaine River Railway Company\", do hereby certify that the above By-law was passed by the directors on the Kith day of August 1949 and that it was unanimously confirmed by all the shareholders at a special meeting duly held on the aforementioned date, V.A.de BILLY, 2589 l-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Breakeyville\" under date the 12th day of September, 1949, whereof the head office is at Ste-Hélène de Breakeyville, county of Levis, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th of September, 1949.JEAN BRUCHÊSI, 25890 Under Secretary of the Province.L'Association Canadienne d'Urbanisme \u2014 Division de la Province de Québec The Community Planning Association of Canada\u2014 Quebec Provincial Division Excerpt from the by-laws of the above mentioned corporation concerning the increase in the number of its directors from four to ten: \"IV \u2014 Administrative Council & Executive Committee (of the Division) \u2014 The administrative Council of ten memliers of the Quebec Provincial Division shall Ik* composed of a president, two vice-presidents with an elected substitute for each, a secretary-treasurer and one delegate for each of the actual and future sections of the Provincial Division.EMILE NADEAU, M.D., 2589 l-o Vice-president.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, on October 5, 1949, enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Le Syndicat National Catholique des Employés de l'Industrie du Cuir et de la Chaussure des Trois-Rivières Inc.\", and such, in conformity with the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, October 8, 1949.JEAN BRUCHÊSI, 25893 Under Secretary of the Province. 8809 GAZETTE OFFICII.I.IE DE QUEBEC.Quebec, 15 octubre 1949, Time 81, N° 41 Amikkto Inc.Extrait du mjlancnt A'° 7A Auikhto Inc.Extract from By-law No.7 A Concernant l'augmentation du nombre des d i rcc- Concerning the increase in the number of directeurs de 8 ù 5 tors from 3 to 6 \"1° Le nombre des directeurs du bureau (le di- \"I.The number of directors forming the hoard motion «le la Compagnie est par les présentes fixé of directors of the company is hereby fixed to à cinq.\" five.\" Certifié extrait conforme.Certified true copy.Ix- Secretaire.HENRI GAGNÉ, 25892-0 HENRI GAGNÉ.25892 Secretary.C.Champoux Inc.En vertu de Particle 90 de la Ixii des Compagnies de Québec, chapitre 276, la compagnie \"C.Champoux Inc.\" donne avis, par les présentes, qu'elle a adopté un règlement pourvoyant à la discontinuation de ses affaires et un règlement autorisant la distribution de ses actifs à ses actionnaires.Québec, le 11 octobre 1949.(Sceau) \\a?*M.*c*rctttirc 25917-o A.EMILE BEAU VAIS, C\\A.Amemcan Pai'Eh Box Co.Limited Règlement N° 80 Attendu qu'il est jugé nécessaire d'augmenter le nombre des directeurs de la compagnie de cinq à six: En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie: Que le nombre des directeurs de la compagnie soit modifié en augmentant le nombre de ces directeurs de cinq à six: Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, modifiés pour se conformer au précédent.Daté de trente septembre, mil neuf cent quarante-neuf.lx' Président.H.H.FOG EL.Le Secrétaire, 25920 HARRY D.FOGEL.C.Chami'oux Inc Under the provisions of Section 90 of the Quebec Companies' Act, Chapter 276, \"C.Champoux Inc.\" hereby gives notice that is has approved a by-law whereby this Company has ceased to carry on business except for winding-up its affairs and has also approved a by-law authorizing the distribution of its assets to its shareholders.Quebec, 11th October 1949.(Seal) A.EMILE BEAUVAIS, C.A., 25917-o Secretary.American Paper Box Co.Limited By-law No.30 \"Whereas it is expedient to increase the number of directors of the company from five to six; Now therefore be it enacted as u by-law of the company : That the number of directors of the company be varied by increasing the number of such directors from five to six; That the by-laws of the company be and they are hereby amended to accord with the foregoing.\" Dated this thirtieth day of September, one thousand nine hundred and forty-nine.H.H.FOGEL, President.HARRY D.FOGEL, 25920-o Secretary.Compagnies autorisées à faire des affaires Companies Licensed to do Business Avis est donné que la compagnie \"Fred Man-nix & Company Limited\", a été autorisé à faire affaires dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à la dite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et sujets aux mêmes formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.L'agent principal de ladite compagnie dans cette Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure intentée contre elle, est M.George W.Hall de la cité de Montréal.1-e bureau principal de la corporation dans cette Province est à 507 Place d'Armes.dans ladite cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Notice is hereby given that the company \"Fred Mannix & Company Limited\" has been authorized to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and subject to the same formalities as are prescril>ed by the existing laws of this Province.The chief agent of the said Company in this Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it, is Mr.George W.Hall of the City of Montreal.The principal office of the Corporation in this Province is at 507 Place d'Armes, in the said City of Montreal, in the Judicial District of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 194$, Vol 81, No.41 2393 Donné au bureau du Secrétaire de la Province, |e 12 octobre 1949.be Sous-secrétaire de lu Province, 25931 JEAN BRUCHÊSI.Avis est donné que lu compagnie \"James Bay Sontli.Incorporated\" a été autorisée à faire allai res dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compuguie pur sa charte seront limités ù ceux uccordés aux corporation! «le même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et sujets aux mêmes formalités telles que prescrites par les bois existantes de cette Province.L'agent principal «le ladite compagnie dans cette Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure intentée contre elle, est M.J.W.Sutherland «le Muniwuki, P.Q., ., \u2022 ¦ Ix?bureau principal de la corporation dans cette Province est au Lac Désert, s/dC.S.Mac-Lean.Maniwaki, P.Q.Donné au bureau «lu Secrétaire de la Province, le 12 octobre 1949.Ix* Sous secrétaire de la Province, ,25921 JEAN BRUCHÊSI.Département the Province of Quebec, und suject to the same formalities us ure prescribed by the existing laws of this Province.The chief agent of the said Company in this Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it, is Mr.J.W.Sutherland of Muniwuki, P.Q.The principal office of the Corporation in this Province is at Lac Desert, c/o C.S.MacLean, Muniwuki, P.Q.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of October.1949.JEAN BRUCHÊSI, 25921-o Under Secretary of the Province.Department of Municipal Affairs The undersigned gives notice that, as requested by a resolution of September 3, 1949, of the Council of the Municipality of St-Maxime du Mont-Louis, county of Gaspé-West, and pursuant to the provisions of article 130 of the Municipal Code, he has authorized, under date of October 7, 1949, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required in the Quebec Official Gazette, be made, in future, in the French language only.The present notice is published in conformity with article 131 of the Municipal Code (10 George VI, chapter 55, section 2) Quebec, October 7, 1949.BONA DUSSAULT, 25896 Minister of Municipal Affairs.The undersigned gives notice, that, as requested by a resolution of September 6, 1949, of the Council of the village of Lotbinière, county of Lotbinière, and pursuant to the provisions of article 130 of the Municipal Code, he has authorized, under date of October 12.1949, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, save those required in the Quebec Official Gazette, be made, in future, in the French language only.The present notice is published in conformity with article 131 of the Municipal Code (10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, October 12, 1949.BONA DUSSAULT, 25922 Minister of Municipal Affairs.Department of Agriculture Notice is hereby given that the farmer's club of the parish of Ste-Famille, I.O., the farmers' club of the parish of St-Féréol, the farmers' club 2394 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° U «le la paroisse St-François de Sales (I.O.), le cercle agricole de la paroisse St-Laurent et le cercle ugricole de la paroisse de Ste-Pétronille, tous cinq dans le comté de Montmorency, ayant négligé pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, cliap.118), le ministre de l'Agriculture les déclara «lis-sous, conformément à l'article 44 «le ladite Loi.Québec, ce 3 octobre 1949.Le Sous-ministre «le l'Agriculture, 25897-0 R.TREPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole «le la paroisse «le Notre-Dame-des-Lau-rentides et le cercle agricole de la paroisse Stc-Foye, tous «leux dans le comté de Québec, ayant négligé, pendant «leux ans, de se conformer aux exigences de la Ix)i des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément à l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 3 octobre 1949.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 25897-0 R.TRÊPANIER.Avis est, par les présentes, donné «pie le cercle agricole de la paroisse St-(Y\\saire, le cercle agricole de la paroisse de St-Hilaire, le cercle agricole de la paroisse St-Jean-Baptiste «le Rouville.le cercle agricole «le la paroisse Ste-Marie de Mon-noir et le cercle agricole «le la paroisse «le St-Paul d'Abbotsford, tous cinq dans le comté de Rouville, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Ix>i des cercles agricoles (S.R.Q.1941.chap.118), le ministre «le l'Agriculture les déclare dissous, conformément à l'article 44 «le ladite Loi.Québec, ce 3 octobre 1949.Le Sous-ministre de l'Agriculture.25897-o R.TRÊPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole du canton de Bergeronnes, le cercle agricole de la paroisse du Sacré-Cœur-de-Jésus et le cercle agricole de la mission St-Jean-Baptiste de la Pointe aux Outardes, tous trois dans le comté de Saguenay, ayant négligé, pendant «leux ans, «le se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les «Irélare dissous, conformément à l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 3 octobre 1949.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 25897-0 R.TRÊPANIER.of the parish of St-François de Sales (I.O.), the farmers' club pf the purish of St-Laurent and the farmers' club of the parish of Ste-Pétronille, all five in the county of Montmorency, having neglected for two years, to comply with the requirements of the Farmers' Club Act (R.S.Q., 1941, chap.118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to section 44 of the said Act.Quebec, October 3, 1949.R.TRÊPANIER, 25897 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the farmers' club of the parish of Notre-Dame-des-Laurentides and the farmers' club of the parish of Ste-Foye, both in the county of Quebec, having neglected, for two years, to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q., 1941, chap.118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to section 44 of the said Act.Quebec, October 3, 1949.R.TRÊPANIER, 25897 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the farmers' club of the parish of St-Césaire, the farmers' club of the parish of St-Hilaire, the farmers' club of the parish of St-Jean-Baptiste de Rouville, the farmers' club of the parish of Ste-Marie de Mon-noir and the farmers' club of the parish of St-Paul d'Abbotsford, all five in the county of Rouville, having ncglecte«l for two years, to comply with the requirements of the farmers' Club Act (R.S.Q.1941, chap.118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to section 44 of the said Act.Quebec, October 3, 1949.R.TRÊPANIER, 25897 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the farmers' club of the township of Bergeronnes, the farmers' club of the parish of Sacré-Cœur-de-Jésus and the farmers' club of the mission of St-Jean-Baptiste de la Pointe aux Outardes, all three in the county of Saguenay, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q., 1941, chap.118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to section 44 of the said Act., Quebec, October 3, 1949.R.TRÊPANIER, 25897 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec Ordonnance N° 44-48B Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi, 5 octobre 1949, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière, à Québec, à 10 heures du matin.Présents: MM.Dr Emile Nadeau, président, Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission or the province or Quebec Order No.U-48B Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Wednesday, October 5, 1949, held in the office of the Dairy Industry Commission, in' Quebec, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Dr Emile Nadeau, President, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.81, So.41 2395 Joseph Hébert, Ojner-E.Milot, commissaires, Joseph Hébert, Omer-K.Milot, Commissioners.Alphonse Savoie, secrétaire.Alphonse Savoie, Secretary.Après avoir considéré les conditions de l'indus- Considering the conditions of the dairy indus- trie laitière dans la région de l'Abitihi try within the region of Abitibi La Commission i>P.c,hkte ce qui suit: I.L'article 2 de l'Ordonnance N° 44-48A, publiée Hans la Gazette officielle de Québec du 17 janvier 1948, est amendé en y ajoutant la municipalité de Xormetal.La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec m Le Secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans le prochain numéro de la Gazette officielle de Québec Signé: MM.Dr Emile Xadeau, président, Joseph Hébert, Omek-E.Milot.Certifié: Alphonse Savoie, Le Secrétaire, Commission, 25914-0 de l'Industrie Laitière.It is en acte d as follows: 1.Article 2 of Order No.44-48A, published in the Quebec Official Gazette of January 17th, 1918.is amended by including the municipality of Nor-metal.The present Order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in the next issue of the Quebec Official Gazette.Signed: Messrs.Dr.Emile Nadeau, president, Joseph Hébert, Omer-E.Milot.Certified: Alphonse Savoie, The Secretary, Dairy Industry, 25914-o Commission.Département de l'Instruction publique Department of Education X° 284-49.Québec, le 29 septembre 1949.No.284-49 Demande est faite de détacher de la munici-' palité scolaire de Stc-Angèle-de-MonnoiY, dans le comté de Rouville, la partie du lot N° 213 appartenant à Monsieur Claudio Tétrcault, et de l'annexer à la municipalité scolaire de Saint-Grégoire, dans le comté d'II)crville.Pour le Surintendant, 25S68-40-2-o Par B.O.FILTEAU.Quebec, September 29, 1949.Application is made to detach from the school municipality of Ste-Angèle-de-Monnoir, in the county of Rouville, the part of lot No.213 belonging to Mr.Claudio Tétrcault, and to annex it to the school municipality of Saint-Grégoire, in the countv of Iberville.B.O.FILTEAU, 25868-40-2 For the Superintendent.X° 1262-45.Québec, le 11 octobre, 1949.No.1262-15 Quebec, October 11, 1949.Demande est faite d'annexer le territoire de la municipalité scolaire de Bonaventure, dans le comté de Bonaventure, à celui de la municipalité scolaire de Cox, dans le comté, et ce pour les Protestants seulement.Le territoire de cette municipalité scolaire est décrit comme suit, savoir: Lot cadastral N° 1 au lot cadastral N° 81 rang I de Xew-Carlisle, ouest; lot cadastral N° 603 au lot cadastral N° 681 rang II, New-Carlisle, ouest; le lot cadastral X° 682, au lot cadastral X° 737, rang III, Xew Carlisle, ouest; le lot cadastral X° 928 au lot cadastral X° 984 rang IV Xew-Carlisle, ouest; le lot cadastral N° 985 au lot X° 1015 rang V New-Carlisle ouest; le lot cadastral X° 1131 au lot cadastral X° 1167 au rang I Paspebiac-Line ouest; le lot cadastral X° 1168 au lot cadastral N° 1197 rang II Paspebiac-Line ouest; le lot cadastral X° 1351 au lot cadastral N° 1358 rang III Pasbebiac-Line ouest; le lot cadastral N° 1359 au lot cadastral X° 1366 rang IV7, Paspebiac-Line ouest, le lot cadastral N° 1471 au lot cadastral N° 1481 rang V Paspepiac-Line ouest; le lot cadastral 1482 au lot cadastral N° 1492 rang VI Paspebiac-Line ouest; le lot 1564 au lot cadastral N° 1582 rang VII Paspebiac-Line ouest; le lot cadastral X° 1875 au lot cadastral N° 1895 rang Bloc Y.l'aspebiac-Line ouest.25910-41-2-o Pour le Surintendant, de l'Instruction publique, B.O.FILTEAU.Application is made to annex the territory of the school municipality of Bonaventure, in the county of Bonaventure, to that of the school municipality of Cox, in the same county, and this for Protestants only.The territory of the said school municipality is described as follows, to wit: Cadastral lot Xo.1 to cadastral lot Xo.81 range I of Xew Carlisle, West; cadastral lot Xo.603 to cadastral lot Xo.681 range II of Xew Carlisle West; cadastral lot Xo.682 to cadastral lot No.737 range III of Xew Carlisle, West; cadastral lot Xo.928 of cadastral lot No.984 range IV of New Carlisle, West; cadastral lot No.985 of cadastral lot Xo.1015 range V of New Carlisle, West; cadastral lot No.1131 of cadastral lot No.1167 range I Paspebiac Line, West; cadastral lot No.1168 to cadastral lot No.1197 range II Paspebiac Line, West; cadastral lot Xo.1351 to cadastral lot Xo.1358 range III Paspebiac Line, West; cadastral lot No.1359 to cadastral lot No.1366 range TV Paspebiac Line, West; cadastral lot No.1471 to cadastral lot Xo.1481 range V Paspebiac Line, West; cadastral lot No.1482 to cadastral lot No.1492 range VI Paspebiac Line, WTest; cadastral lot No.1564 to cadastral lot No.1582 range VII Paspebiac Line, West; cadastral lot No.1875 to cadastral lot No.1895 range Block Y Paspebiac Line, West.B.O.FILTEAU, For the Superintendent 25910-41-2 of Education. 2390 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEllEC, Québec, 16 octobre 19^0, Trnne 81, N° kl N° 875-49.Québec, le 11 octobre 19-19.Demande est faite «le détacher de la municipalité scolaire «le l'ointe-Claire, «lans le comté «le Jacques-Cartier, les lots 108 et 109 et leurs subdivisions «lu cadastre officiel «le Pointe-Claire, et «le les annexer à la municipalité scolaire «le Sainte-Jeanne-f the village of Lauzon to that of \"The School Municipality of Lauzon\", in the county of l.evis.B.0.FILTEAU, for the Superintendent 25915 of Education.No.475-49.Quebec, October 12, 1949.Application is made to detach from the school municipality of Saint Moise, in the county of Ma-taptnlia, lot 13 of range II, in the township of Awantjish; lots 14 and 15 of range III, of the same township, ami to annex them to the school municipality of La Rédemption, in the same county.Per B.O.FILTEAU, 25925-41-2 For the Superintendent.No.905-48.Quebec, October 12, 1949.Application is made to detach from the school municipality of Saint-Pierre de Broughton, in the county of Beauce, lots 16 to 18 inclusively of range X, of the township of Leeds; 15 to 18 inclusively of range XI, of the same township; the half of lot 16 belonging to Mr.Thomas Laughrca and 17 to 21 inclusively of range XII, of the same township, and to annex them to the school municipality of Saint-Jacqucs-er the 12th, 1949.Department of Lands an«l Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 25910-o Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION I,'In moral île Antonio Barrette, Ministre «lu Travail, donne avis par les présentes, conformément aux «lispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québee 1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire du commerce de détail «le Richmond-Melbourne lui a présenté une requête à l'effet de modifier le décret numéro 2861 du 17 juillet 1946 et amendement, relatif aux établissements commerciaux «le lu ville de Richmond et de la municipalité «le Melbourne.On demande: 1° Que l'article IX soit remplacé par le suivant : \"IX.Vacances payées: Après une année de service tout,employé a droit à un congé annuel payé d'une semaine basé sur 2% de son salaire de l'année écoulée.En cas de fraction d'année, tout employé a droit à un congé payé «l'une demi-journée par mois calculé uu prorata «le 2% de son salaire pour cette fraction d'année.\" Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement.Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of Richmond's and Melbourne's Retail Trade has submitted to him a petition to amend the decree number 2861 of July 17, 1946, and amendment, reltaing to the commercial establishments in the town of Richmond and the municipality of Melbourne.It is requested: 1.That section IX be replaced by the following: \"IX.Vacation with pay: After one year ne half-day per month, computed at the prorata of 2% of his wages for the period worked.\" 2398 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 15 octobre 191$, Tome 81, N° U 2° Que l'urtiele XIV soit remplacé par le suivant : \"XIV.Dans le cas où l'employeur loge et nourrit son employé, il a le privilège d'exiger de ce dernier un montant n'excédant pas $1.00 (quatre dollars) par semaine pour chambre et pension ou $1.25 (un dollar et vingt-cinq sous) par semaine pour la chambre seulement.\" 3° Que les mots \"vingt-cinq cents ($0.25) de l'heure\" mentionnés à l'article XV soient remplacés par les mots \"trente-cinq cents ($0.35) de l'heure\".4° Que l'article XVI soit remplacé par le suivant : \"XVI.Salaire* minima: \\jc taux de salaires pour les salariés des deux sexes ne doit pas être inférieur à ceux ci-après mentionnés: 75% Classe A.$10.00 25%\u2014Classe B.13.00 lie taux de salaire «l'un apprenti est de $12.00 par semaine; après six mois d'expérience, il doit recevoir le taux de salaire prévu pour la classe à laquelle il appartient, selon la proposition suivante : ( 'lasses Un ( 1 ) employé.A B Six premiers mois.1 Six mois et plus.1 Deux (2) employés.1 1 Trois employés.2 1 Quatre (4) employés.3 1 Cinq (5) employés.4 1 Six (0) employés.'.4 2\" Durant les trente jours a compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Ix: Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 octobre 1949.25930-o 2.That section XIV be replaced by the following: \"XIV.When the employer lodges or boards his employee, he bus the privilege of charging that employee an amount not exceeding $4 00 j>er week for room and hoard, or $1.25|>er\\vcck for room only.\" 3.That the words \"twenty-five cents ($0.25) per hour\" mentioned in section XV he replaced by the words \"thirty-five cents ($0.35) per hour\".4.That section XVI he replaced by the following: \"XVI.Minimum uayex: The rates of wages for male and female employees shall not be less than the following ones: 75%\u2014Class A $10.00 25%\u2014Class B.13.00 The wage rate of an apprentice is $12.00 per week; after six months of experience he shall receive the rate determined for the class to which he belongs, accroding to the following proportion: Classes One (1) employee.A B First six months.1 After six months.1 Two (2) employees .,'.1 1 Three (3) employees.2 I Four (4) employees.3 I Five (5) employees.4 1 Six (0) employees.4 2\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Officiul Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, Octol>er 15, 1949.25930-n AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de l'imprimerie dans le district de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 3088 du 7 août 1940, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements, de la façon suivante: 1° Le paragraphe 1 de l'article I sera remplacé par le suivant : \"1.Pour les fins d'application du présent décret, la juridiction professionnelle désigne et comprend : a) Toute personne employée à produire des imprimés par le procédé d'impression typographique (letter press process), les procédés de multicopie de toute description, la composition, l'impression, le coupage, le réglage, la reliure, et la finition, soit dans un atelier spécialisé, une entreprise privée, industrielle ou commerciale, ou dans tout autre établissement, et soit que telles opérations constituent le commerce principal de telle entreprise ou qu'elles soient secondaires à tout autre commerce ou occupation.b) Toutes personnes employées à la production de lithographie commerciale par les procédés lithographique, planographique ou photo-lithographique, lorsque telle production est faite par une machine de format 14 x 20 ou moindre; NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Labour Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the Collective Labour Agreement relating to the Printing Trades in the district of Montreal, rendered obligatory bv Decree No.3088 of August 7, 1946, have \"submitted to him a request to amend the said decree, and its amendments, as follows: 1° Subsection 1 of section I will l>e replaced by the following: \"1.For the purposes of the present Decree, the professional jurisdiction designates and comprises: a) All persons engaged in the production of printing by \"Letter Press\" process, multi-copying processes of every description, typesetting, press work, cutting, ruling, bookbinding and finishing, whether in trade plants, private, industrial, commercial or any other establishment, and whether such operations constitute its principal business or are accessory to some other busmess or enterprise.b) All persons engaged in the production of lithography by lithographic, planographic or photolithographic processes when produced by machines or a press size up to and including 14 x 20 inches, whether in trade plants; private, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.81, So.41 2399 soit qu'elles soient employees dans une entreprise industrial, commercial or any other establish- privée ou industrielle ou commerciale ou clans ment and whether such operations constitute tout autre établissement, et soit que telles opé- its principal business or are accessory to some rations constituent le principal commerce de other business or enterprise, l'entreprise ou qu'elles soient accessoires a tout autre commerce ou occupation; e) Tous les o|>érateurs de chassis pneumatique c) All vacuum frame and contact negative et cle contacts négatifs employés à la préparation oj>erators producing plates for reproduction by de plaques pour lu reproduction pur machines à multicopying machines of a press size up to and polycopier de format 14 x 20 ou moindre; including 14 x 20 inches.d) Toute personne employée ù des opérations e as specified in \\ du présent décret et s'applique à chaque Section X of the present Decree and shall apply département et à chaque équipe.to each department and each shift./) Lorsqu'une ou plusieurs personnes, indivi* /) In all cases where one or more persons, (luellement ou en société, exécutent comme con- individually or in partnership, perform as tractants tout travail régi par le present décret contractors any work covered by this Decree et habituellement accompli par des salariés, ces and ordinarily performed by employees, all such personnes sont considérées comme étant elles- persons shall be deemed to be employees and mêmes des salariés et sont assujetties aux dispo- shall be subject to the provisions of the present sit ions du présent décret de la même manière et Decree in the same manner and to the same au même degré (pie lesdits salariés.\" extent as such employees.\" 2° Les alinéas V et \"/\"' du paragraphe 2 de 2° Paragraphs \"e\" and \"/\" of subsection 2 l'article I seront remplacés par les suivants: of section I will l>e replaced by the following: \"e paid as follows : per hour if the employer owns and keeps the bicycle in repair .».$0.15 if the employee owns and keeps the bicycle in repair.0.20 \" 3.Section X will be replaced by the following: \"X.The employer shall pay for the renting and cleaning of his clerks' uniforms.\" 4.Section XI will be replaced by the following: \"XI.When the employer lodges or boards his employee, he has the privilege of charging that employee an amount not exceeding $4.00 |>er week for room ami board, or $1.25 per week for room only.\" 5.Section XII will be replaced by the following \"XII.Vacation with pay: After one year of service, every employee is entitled to an annual vacation with pay at the rate of 2% of his wages QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October loth, 1949, Vol.SI, A'o.41 de 1'uiiihV éCQUléSi En cas «le fraction d'année, tiuit salarié u droit ù un congé payé d'une demi* journée pftf mois, calculé au prorata de 2% de miii salaire de cette fraction d'année.\" (i° L'article XIV sera remplacé pur le suivant: \"XIV.Tout salarié embauché «le façon intermittente ou spécialement, en plus du personnel régulier! à l'occasion de certaines circonstances ou pouf certuines parties «le semuines, ou travaillant moins de ciuquante-f Saint-Fa-bien-«le-Panet.county of Montmagny; A section of 1045 feet, northeast of the new highway, on or facing lots Nos.10 and 17 of range IV.Quebec, October 5, 1949.ANTONIO TALBOT, 25899 Minister of Roads.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination Noms Names BARREAU DE QUÉBEC \u2014 BAR OF QUEBEC Candidats pour l'admission à l'étude du droit Candidates for the admission to the study or law Prénoms Surnames Age Résidence Residence Collèges Colleges Thibault.Morin Beaupré Normandin.Miville-Dechêne Lucille.Callin Jacqueline Paul.André .DuBSault.( 'hail 22 21 19 22 23 25 Québec St-Henri, Cté de Levis.Québec Québec Québec Québec Couvent Bon-Pasteur (L'Islet), Ecole Ouellot, (Québec), Ursùlines de Québec.Ecole St-Henri de Levis, Couvent Jésus-Mario de Lauzon, Collège Jésus-Marie de Sillery.St-Joseph de St-Vallicr (Québec), Collège des Ursùlines (Québec).Collège des Jésuites, Professeur Michaud.Université d'Ottawa.Collège des Jésuites, Séminaire de .loiiette.Professeur Michaud, Université d'Ottawa.Collège des Jésuites, Université d'Ottawa.Québec, le 12 octobre 1949 \u2014 Quebec, October 12th, 1949.25927-4 l-2-o Le Secrétaire du Barreau de Québec, ROGER THIBAUDREAU, Secretary of the Bar of Quebec* 2402 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 Lettres patentes Le phêt hypothécaire Avis est donné qu'on vertu de la dexième partie de la Loi ties compagnies île Québec, il a été accordé, par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27 septembre 1949, subdivisant les 5,000 actions de $100.00 chacune du capital de \"Le Prêt Hypothécaire\" en 50,000 actions de $10.00 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 27 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 25923-0 L.DÉSILETS.Nominations Il a plu ù Son Honneur le Lieuteuant-gouver-verneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, de nommer par lettres patentes sous le grand sceau de la province, au nom de Sa Majesté, la personne dont le nom suit, savoir: Québec, 28 septembre 1949.M.Leopold Larouche, de Rouyn, membre du Barreau de la Province: conseil en loi du Roi.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, et par commissions, de faire les nominations suivantes: Québec, 11 août 1949.M.Antonin Bourassa, qui agit conjointement avec monsieur Elisée Gaudet en qualité de protonotaire de la Cour supérieure, greffier de la Cour de circuit, greffier de la Cour de magistrat, greffier de la Couronne et greffier de la paix du district de Bedford, à Sweetsburg: juge de paix, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1941, chapitre 15), avec juridiction sur le district judiciaire de Bedford, telle juridiction cependant devant être restreinte à la réception des serments, à la réception des plaintes, à l'émission des mandats d'arrestation et de recherches, de brefs de sommation, de subpoenas et de mandats de dépôt, ainsi qu'à la réception des cautionnements et à l'ajournement des causes, soit seul lorsque la loi le permet, soit de concert avec un autre juge de paix lorsque la loi donne juridiction n deux juges de paix.Québec, 28 septembre 1949.M.Leopold Larouche, avocat, de Rouyn: magistrat de district pour les districts judiciaires d'Abitibi et de Rouyn-Noranda, avec, en outre, juridiction concurrente avec les autres magistrats de district dans toute l'étendue de la Province, à compter du 10 octobre 1949.25929-0 Sièges Sociaux Avis est donné que la compagnie \"Caswell Construction (Quebec) Limited\", incorporée par lettres patentes en date du 10 mai 1949, et ayant son siège social en la cité de Rouyn où son bureau Letters Patent Le Prêt Hypothécaire Notice d given that under Part II of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenunt-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-seventh day of September, 1949, subdividing the 5,000 shares of $100 each, of the capital stock of \"Le Prêt Hvpothécaire\", into 50,000 shares of $10 each.Given at the office of the Attorney General, September 27, 1949.L.DÉSILETS.25923 Deputy Attorney General.Appointments His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, to appoint by letters patent under the Great Seal of the Province, in the name of His Majesty, the person whose name follows, to wit: Québec, September 28, 1949.Mr.Leopold Larouche, of Rouyn, member of the Bar of the Province: King's Counsel.His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, to make the following appointments: Quebec, August 11, 1949.Mr.Antonin Bourassa, who acts jointly with Mr.Elisée Gaudct as Prothonotary of the Superior Court, Clerk of the Circuit Court, Clerk of the Magistrate's Court, Clerk of the Crown and Clerk of the Peace for the district of Bedford, at Sweetsburg: to be a Justice of the Peace, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 1941, chapter 15), with jurisdiction over the judicial district of Bedford, such jurisdiction however, to be restricted to the administering of the oath, the swearing of complaints, the issue of arrest and search warrants, writs of summons subpoenas and warrants of custody, as well as the receiving of sureties and the adjournment of cases, either alone when the Law permits it, or with another Justice of the Peace when the Law gives jurisdiction to two justices of the Peace.Quebec, September 28, 1949.Mr.Leopold Larouche, advocate, of Rouyn: to be District Magistrate for the judicial districts of Abitibi and Rouyn-Noranda, with, moreover, concurrent jurisdiction with the other district magistrates throughout the whole Province, as from the 10th of October, 1949.25929 Head Offices Notice is hereby given that \"Caswell Construction (Quebec) Limited\", incorporated by letters patent on the 10th day of May, 1949, and having its head office in the City of Rouyn was QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 1949, Vol.81, No.U 2403 étftit étalé jusqu'à M jour ù 32 rue Principale, l'a t rausporté au bureau légal de Marc Fortin, c.r, à 129 rue Principale, en la cité de Rouyn, province de Québee.Daté de 20 septembre 1949.ISceau] I^e Secrétaire, 25024 GERALD D.O'MEARA.ART Construction Ltd .l'.xlrait des minutes d'une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 22 septembre 1949: .\"'Il est résolu unanimement que le bureau ou domicile de la Compagnie ou siège principal de ses affaires actuellement en l'Édifice Micliaud, au numéro 3 de la rue Sacré-Cœur à St-.Ioseph (lAlma, P.Q.soit et il est par les présentes fixé sur la rue Principale dans le village de St-Êmi-licn de Desbiens, comté de Lac St-Jean.\" Vraie copie certifiée.Le Président, ARTHUR DOUCET.Le Secrétaire, 26000*0 LAURENT PARENT.Extrait des Minutes d'une Assemblée des Directeurs de \"Marché de Fruits Jacques-Cartier Ltée\", tenue le 15 septembre 1949, à 11 lires a.m., au bureau du secrétaire.\"Sur proposition dûment secondée, il est résolu que le bureau-chef «le la compagnie soit au No.379 «le la rue St-Joseph, à Québec.\" (Sceau) Certifiée vraie copie.Le Secrétaire, 2Ô902-o WILBROD BHÉRER, C.R.R.Martineau, Limitée Avis est par les présentes donné que la Compagnie \"R.Martineau, Limitée\", dûment incorporée par Lettres Patentes «le la Province de Québec en date du 14 juin 1949 et ayant son siège social en la cité de Montréal, a établi son siège social à 857 rue St-Maurice, Montréal.A compter de la date du présent avis le dit bureau sera considéré par la Compagnie comme étant son siège social Daté à Montréal, le vingt-huitième jour «lu mois de septembre, mil neuf cent quarante-neuf (1949).Le Secrétaire, 25913-o G ÊRALD DALCOURT.Soumissions situute«l up to to-day at 32 rue Principale, has moved it to the law office of Marc Fortin, K.C., at 129 rue Principale in the city of Rouyn, in the Province of Quebec.Dated this 20th day of September, 1949.JSeal] GERALD D.O'MEARA, 25924-0 Secretary.AltT CONSTRUCTION LTD.Excerpt from the minutes of a special general meeting of the shareholders held on September 22, 1949.\"It is unanimously resolved that the office or domicile of the company, or its head business office, actually in the Michaud Building, at No.3 Sacré-Cœur Street, St-Joseph d'AIma, P.Q.be and it is hereby moved to Principale Street, in the village of St-Émilien de Desbiens, county of Lake St.John\".Certified True Copv.ARTHUR DOUCET.President.LAURENT PARENT, 25900 Secretary.Excerpt from the Minutes of a Meeting of the Directors of \"Marché des Fruits Jacques-Cartier Ltée\", held on September 15, 1949, at 11 o'clock a.m., at the Secretary's office.\"Upon its being moved and duly seconded, it is resolved that the head office of the company bt at No.379 St.Joseph Street, Quebec.\" (Seal) Certified True Copy.WILBROD BHÉRER K.C., 25902 Secretary.R.Martineau, Limitée Notice is hereby given that \"R.Martineau, Limitée\" incorporated by Letters Patent of the Province of Quebec, dated the 14th day of June 1949, and having its Head Office in the City of Montreal, has established its Head Office at 857 St.Maurice Street, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the Head Office of the Company.Dated at Montreal, the twenty-eighth day of September, Nineteen hundred and forty-nine (1949).GERALD DALCOURT, 25913-o Secretary.Tenders Province de Québec Commission Scolaire Catholique de la ville de Mont-Royal Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, au bureau de la commission scolaire catholique de la ville «le Mont-Royal, 1345 avenue Régent, le 19 octobre 1949, à 8 heures 30 p.m., pour l'achat d'obligations au montant de $180,000 remboursables par séries en vingt ans, datées du 1er août 1949 et émises sous l'autorité d'une résolution des commissaires d'écoles pour la municipalité scolaire passée le 31 janvier 1949.Lesdites soumis- Province of Quebec Catholic School Commission or the Town or Mount Royal Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, at the office of the Catholic School Commission of the Town of Mount Royal, 1345 Regent avenue, on the 19th of October, 1949, at 8.30 o'clock P.M., for the purchase of bonds to the amount of $180,000 redeemable serially in twenty years, dated the 1st of Augdst, 1949, and issued under authority of a resolution of the School Commissioners for the school municipality passed on the 31st of Ja- 2404 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 octobre 19*9, Tome 81, N° kl sions devront mentionner le tous «rintérêt dee- dites obligations un choix du soumissionnaire, lequel tOUI ne devra pas cependant excéder 8] //v et le taux offert peut être le môme pour toute l'émissiou ou il petit varier suivant les échéances, l/intérct sera payable seini-annuelleincnt les 1er août et 1er février de chaque unnée.Ix« tableau d'amortissement est le suivant: Taldeau d'amortissement\u2014$180,000\u201420 ans Année Capital 1er août 1950.x$2(),500.00 1er août 1951.21,000.00 1er août 1952 .20,500.00 1er août 1953 .5,000.00 1er août 1954.5,000.00 1er août 1955.5,500.00 1er août 1950.5,500.00 1er août 1957.0,000.00 1er août 1958 .0,000.00 1er août 1959 .0,500.00 1er août 1900 .0,500.00 1er août 1961.7,000.00 1er août 1962.7,000.00 1er août 1963 .7,500.00 1er août 1964 .7,500.00 1er août 1965 .8,000.00 1er août 1966 .8,500.00 1er août 1967.8,500.00 1er août 1968 .9,000.00 1er août 1969 .9,000.00 I^s x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $50,000 accordé par le Secrétaire de la province et payable en deux versements de $17,000 et un versement de $16,000 «le 1950 à 1952 inclusivement, senmt reçus et appliqiu's au service «le cet emprunt.I^e capital et les intérêts seront payables au bureau principal de lu banque dont le nom est mentionné «lans la procédure «l'emprunt, à Montn-al ou à tout autre endroit qui pourra être «l«''terminé par résolution «le la Commission.Lesdites obligations pourront, en vertu de l'autorité du chapitre 212 des Statuts refomlus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, à toute date d'échéance d'intérêt, au pair; cei>ener, 1949.ADRIEN PERREAULT, 25903 Secretary-Treasurer.Province de Québec Village de Plessisville (Comté «le Mégantie) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et emlossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné jusqu'à 8 heures p.m., lundi le 7 novembre 1949, pour l'achat de $45,000 d'obligations de Province de Queliec Village of Plehsisville (County of Megantic) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Rontls\" will be received by the undersigned, until 8 o'clock p.m., on Mon«lay, Noveml>er7, 1949, for the purchase of $45,000 of bonds of the municipality of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lôth, 1949, Vol.HI, So.U In municipalité «lu village «le Plessisville, comté de Mégantie, dotées «lu 1er octobre 1949 et remboursables par séries «lu 1er octobre 1950 Ml 1er octobre 1904 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excé«lant pas 3^£% par année, payable semi-aniiuellcmcnt les 1er avril et 1er c redeemed will be called in reverse onler of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepte» 1 cheque, equal to 1% of the total amount of the loan and must specify whether the price offerc«l includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council.Monday the 7th day of November, 1949, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall.The Council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Plessisville, this 5th «lav of October 1949.MARCEL COLLIN, 25904-o Secretory-Treasurer.Province of Quebec Municipality of St-Roch-de-Mékinac (County of Champlain) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\", will be received by the undersigned up to 8 o'clock P.M., on Wednesday, November 2nd.1949, for the purchase of $56,000 of bonds of the municipal corporation of St-Roch-de-Mékinac, dated September 1st, 1949, ami payable serially, from September 1st, 1950, to September 1st, 1964, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3^2% per annum payable semi-annually, on the 1st of March and 1st of September of each year.Interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The tabic of redemption is as follows: Table of Redemption\u2014$5G,000\u201415 years Year Capital September 1, 1950.$3,500.00 2100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec.15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 |«f septembre 1951.3,500.00 1er septembre 1952.l.ooo.oo 1er septembre 19&8.l.ooo.oo 1er leptembre 1951.l.ooo.oo lerieptembre 1955.1,000.00 1er leptembre 1950.1,000.00 1er leptembre 1957.1,000.00 1er leptembre 1088.l.ooo.oo lerieptembre 1959.1,500.00 1er leptembre 1080.1,500.00 lerieptembre 1001.1,500.00 1er septembre 1902.1.500.00 1 er leptembre 1903.1.500.00 1er septembre 1904'.28,500.00 Le capitul et les intérêts sont payables ù lu banque dont le nom est mentionné dans lu procédure demprunt à Montréal, à Québec ou à St-Tite.Ces obligations pourront être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt, en vertu des dispositions du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Cheque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Ld soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue le 2 novembre 1949, à 8 heures p.m., au bureau du secrétaire-trésorier de St-Roch-de-Mékinac.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Roch-de-Mékinac, ce 1er octobre 1949.Le Secrétaire-trésorier, 25905-o GEORGES DESCHENES.September 1, 1951.3,500.00 September l.1952.4,000.00 September 1, 1068.4,000.00 September 1.1954.1,000.00 September 1, 1955.1,000.00 September 1, 1906.1,000.00 September 1.1957.1,000.00 September 1, 195K.1,000.00 September 1, 1959.1,500.00 September 1.1900.1,500.00 September 1.1901.1,600.00 September 1.1068.1,500.00 September 1, 1068.1,500.00 September 1, 1904.28,500.00 ¦ Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or St-Tite.These bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, ar par, on any interest payment date, under the provisions of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption l>e partial, the bonds to Ik?redeemed will be called in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan, and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will l>e opened and considered at a meeting of the Council to be held on November 2, 1949, at 8 o'clock P.M., at the office of the Secretary Treasurer of St-Roch-de-Mékinac.The Council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.St-Roch-de-Mékinac, Octolwr 1, 1949.* GEORGES DESCHENES, 25905 Secretary Treasurer.Province de Québec Province of Quebec Ville de Bedford (Comté de Missisquoi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné jusqu'à 8 heures p.m.mercredi le 2 novembre 1949.à l'hôtel-de-ville de Bedford, pour l'achat de $50,000 d'obligations de la Corporation de la Ville de Bedford, comté de Missisquoi, datées du 1er novembre 1949 et remboursables par séries du 1er novembre 1950 au 1er novembre 1909 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3^2% par année payable scmi-annuellement \u2022le 1er mai et le 1er novembre\" de chaque année.L'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.I.e tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$50,000\u201420 ans Année Capital 1er nov.1950.$2,000.00 1er nov.1951.2,000.00 1er nov.1952.2,000.00 1er nov.1953.2,000.00 1er nov.1954.2,000.00 1er nov.1955.2.000.00 1er nov.1956.2,000.00 1er nov.1957.2,000.00 1er nov.1958.2,500.00 1er nov.1959.2,500.00 1er nov.1960.2,500.00 1er nov.1961.2,500.00 1er nov.1962.2,500.00 1er nov.1963.3,000.00 1er nov.1964.3,000.00 Town of Bedford (County of Missisquoi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will l>e received by the undersigned up to 8 o'clock p.m.Wednesday, November 2nd, 1949, at the Town Hall at Bedford, for the purchase of $50,000 of bonds of the corporation of the Town of Bedford, county of Missisquoi, dated the 1st of November, 1949.and redeemable serially from the 1st of November, 1950 to the 1st of November 1969 inclusively, with interest at a rate not exceeding 3%% per annum, payable semi-annually on the 1st of May and on the 1st of November of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of Redemption\u2014450,000\u201420 years Year Capital Nov.1st 1950.$2.000.00 Nov.1st 1951.2.000.00 Nov.1st 1952.2.000.00 Nov.1st 1953.2,000.00 Nov.1st 1954.2,000.00 Nov.1st 1955.2,000.00 Nov.1st 1956.2,000.00 Nov.1st 1957.2,000.00 Nov.1st 1958.2,500.00 Nov.1st 1959.2,500.00 Nov.1st 1960.2.500.00 Nov.1st 1961 .2,500.00 Nov.1st 1962.2,500.00 Nov.1st 1963.3,000.00 Nov.1st 1964.3,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 191*9, Vol.81, No.U 2407 1er nov.1905.3,000.00 1er nov.1900.3,000.00 1er nov.1907.3.000.00 1er nov.190S.3.000.00 1er nov.1909.3,500.00 |.c capital et les intérêts sont payables à lu banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'.nipiiint à Montréal, à Québec ou à Bedford.Les dites obligations pourront, en vertu des dispositions du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, à toute échéance d'intérêt, au pair; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant total de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil municipal de la Corporation de la Ville de Bedford, comté de Missisquoi, devant être tenue à 8 heures p.m., mercredi le 2 novembre 1949, à l'hôtel-de-ville de Bedford.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la pins haute ni aucune des soumissions.Daté à Bedford, ce lOèmc jour d'octobre 1949.Le Secrétaire-trésorier.36812* ÊMILE-E.DEMERS.Nov.1st 1905.3,000.00 Nov.1st 1066.8,000.00 .Nov.1st 1907.3,000.00 Nov.1st 1908.3,000.00 Nov.1st 1909.3.500.00 Capital and interest ure payable at the hank mentioned in the loan procedure in Montreal, in Quebec or in Bedford.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest payment dale, under the authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial, the bonds to l>e redeemed will l>e called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the total amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.The tenders will be opened and considered at a meeting of the municipal council of the corporation of the Town of Bedford, to be held at 8 o'clock p.m.Wednesday, November 2nd, 1949, in the Town Hall of Bedford.The council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Dated at Bedford, this 10th day of October.1949.EMILE E.DEMERS, 25912-o Secretary-Treasurer.Province de Québec Commission scolaire protestante de M cM aster ville (Comté de Verchkres) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné jusqu'à 8 heures P.M., mercredi, le 2 novembre 194!), pour l'achat d'une émission de $42,-500 d'obligations de la commission scolaire protestante de McMasterville, datées le 1 août 1919, et remboursables par séries du 1er août 1950 au 1er août 1904 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pus 3J-' 2% par année payable semi-anuuellement les 1er février et 1er août de chaque année.L'intérêt peut-être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Province of Quebec McMasterville Protestant School Commission (county of VeRCHÈREs) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\", will be received by the undersigned until 8 o'clock P.M.on Wednesday.November 2nd, 1949, for the purchase of an issue of $42,500 of bonds of the McMasterville Protestant School Commission, dated August 1st, 1949 and redeemable serially from August 1st, 1950 to August 1st, 1964 inclusively,\" with interest at a rate not exceeding 3|4% Paj\" annum payable half-yearly on the 1st of February and the 1st of August of each year.The interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement\u2014$1*2,500\u201415 ans.Année Capital 1er août 1950.x$l7,500.0() 1er août 1951.500.00 1er août 1952 .500.00 1er août 1953.500.00 1er août 1954.500.00 1er août 1955 .500.00 1er août 1956 1,000.00 1er août 1957.1,000.00 1er août 1958.1,000.00 1er août 1959.1,000.00 1er août 1900.1,000.00 1er août 1901.1,000.00 1er août 1902 1,000.00 1er août 1963.1,000.00 1er août 1964.14,500.00 Table of Redemption\u2014$l?.5O0.\u201415 years Year Capital August 1st, 1950 .x$17,500.00 August 1st, 1951 .500.00 August 1st, 1952 .500.00 August 1st, 1953 .500.00 August 1st, 1954 .500.00 August 1st, 1955 .500.00 August 1st, 1956 .1,000.00 August 1st, 1957 .1,000.00 August 1st, 1958 .1,000.00 August 1st, 1959 .1,000.00 August 1st, 1900 .1,000.00 August 1st, 1901 .1,000.00 August 1st, 1902 .1,000.00 August 1st, 1903 .1,000.00 August 1st, 1904 .14,500.00 La lettre \"x\" indique l'année durant laquelle The letter x indicates the year in which a un ex'troi de $17,500 accordé par le Secrétaire «le grant of $17,500.granted by the Provincial Seul Province, payable en un versement, sera cretary and payable in one instalment shall be reçu et appliqué au service de cet emprunt.received and applied to the service of this loan. 2408 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'EllEC, Québec, 15 octobre 101*9, Tome 81, N° 1*1 Lj capital et les intérêts sont payables à lu banque dont le nom est mentionné «lans la pro- eédure* d'emprunt à Bekeil, Québee ou Montréal.Les «lites obligations pourront, roui l'autorité «lu chapitre 212 «les Statuts refondus de Québec être rachetées par anticipation, eu tout ou en partie, au pair, à toutes échéances «l'intérêt; si tel rachat est partiel, il alfectera l«-s échéances les plus éloignées et h's numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% «lu montant total de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment «le leur livraison.Les soumissi«>ns seront ouvertes et considérées il une séance «les commissaires qui sera tenue à S heures p.m., le mercredi 2 novembie 1949, à l'école à McMasterville.Les commissaires se réservent le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.McMasterville.comté «le Verchères.ce 12ième jour «l'octobre 1949.Le Secrétaire-trésorier.25931 ALEX W.RITCHIE.Capital ami interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure at Bekeil, Quebec or Montreal.The said b«>nds may, under authority of chapter 212 of the Re vised Statutes «>f Quebec, 1941, be re.deemed by anticipation, in whole or in part, ut par, on any interest maturity «late; however, if such rédemption be partial, the bonds t«> be redeemed will be calle«l in reverse order of maturity ami serial number.Bach tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amounl of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bomls to time of their delivery.Tenders will be opened ami considered at a meeting of the Commissioners to be held at S.00 o'clock P.M.on Wednesday, November 2nd, 1949, at the School House at McMastcr-ville.The Commissioners ec.Ces obligations pourront être rachetées par anticipation, au pair, à toute échéance d'intérêt, en vertu des dispositions du chapitre 212, Sta- Tablc of redemption \u2014 $00,000.\u2014 15 years Years\t\tCapital\t October 1st,\t1950\t.$3,000.\t00 Octol>er 1st,\t1951.\t.3,000\t00 October 1st,\t1952.\t.3,500.\t00 October 1st,\t1953\t.3,500.\t00 October 1st,\t1954.\t.3,500\t00 October 1st.\t1955.\t.4,000\t00 October 1st,\t1956.\t.4,000\t00 October 1st,\t1957\t.4,000\t00 October 1st,\t1958\t.4,000\t00 October 1st,\t1959.\t.4.000\t00 October 1st,\t1960\t.4,500\t00 October 1st,\t1961\t.4,500\t00 October 1st,\t1902\t.4,500\t00 October 1st,\t1963\t.5.000\t00 October 1st,\t1904\t.5,000\t00 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure in Ste.Thérèse' in Montreal or in Quebec.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941.subject to be redeemed by anticipation in whole QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lôth, 1919, Pet 81, So.1*1 2409 tills refondus do Québec, 1941; cependant, si tel railial est partiel, il uflectera les échéances les plul éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque .soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pus les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livruisou.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le.31 octobre 1949, à K heures de l'après-midi, à l'hôtel de ville de Ste-Thérèse.comté de Terre-bonne.|,e conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Donné à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, ce septième jour d'octobre, mil neuf cent quarante-neuf.\\jc Secrétaire-trésorier, 25032-0 J.-A.LAJEUNESSE.Province de Québec < ().\\l.MISSION' SCOLAIRE DE St-EtIENNE DE LaUZON (Comté de Lévis) Avis public est par les présentes donné que «les soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné jusqu'à 8 heures de l'après-midi, lundi le 31 octobre 1949.pour l'achat de §40,000 d'obligations de la commission scolaire de St-Kticnne.comté de Levis, datées du 1er novembre 1949 et remboursables par séries du 1er novembre 1950 au 1er novembre 1909 inclusivement avec intérêt à un taux n'excédant pas 3^2% par année payable semi-annuellement les 1er novembre et 1er mai de chaque année.L'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Tableau d'amortissement\u2014$1*0,000\u201420 ans Année Capital I novembre 1950.x$5,500.00 1 novembre 1951.x 0,000.00 * 1 novembre 1952.x 6,000.00 1 novembre 1953.x 0.500.00 1 novembre 1954.1,000.00 1 novembre 1955.1,000.00 I novembre 1950.1,000.00 1 novembre 1957.1,000.00 1 novembre 1958.1,000.00 1 novembre 1959.1,000.00 1 novembre 1900.1.000.00 1 novembre 19G1.1,000.00 1 novembre 1962.1,000.00 I novembre 1963.1,000.00 1 novembre 1964.1.000-.00 1 novembre 1905.J,000.00 1 novembre 1966.1,000.00 1 novembre 1967.1,000.00 1 novembre 1968.1.000 00 1 novembre 1969.1.000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $23,-2S0.accordé par le Secrétaire de la Province et payable en quatre versements de 85,820.chacun de 1950 à 1953 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Charny.Ces obligations pourront être rachetées par anticipation, au pair, à toutes échéances d'in- or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of a partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Much tandif must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must ¦pacify whether accrued interest on the bonds to the time of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to Ikî held on Monday, Octoln'r 31st 1949.at 8 o'eloek in the afternoon at the Town Hall of Ste.Thérèse, County of Terrebonne.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Sainte-Thérèse, County of Terrebonne, this seventh day of Octolier 1949.J.-A.LAJEUNESSE, 25932-o Secretary-Treasurer.Province of Quebec School Commission of St-Etienne de Lauzon (County of Levis) Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Ponds\" will l>e received by the undersigned until 8 o'clock in the afternoon, Monday.October 31st, 1949, for the purchase\" of an issue of $40,000.of bonds of the School Commission of St-Êtienne, county of Levis, dated November 1st, 1949, and redeemable serially from November 1st, 1950 to Noveml>cr 1st, 1969 inclusively, with interest at a rate not exceeding 3^2% per annum payable semi-annually on the first day of November and the fust day of May of each year.The interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Table of Redemption\u2014940,000.\u201420 years Year Capital November 1st, 1950.x$5,500.00 November 1st, 1951.x 6,000.00 November 1st, 1952.x 0,000.00 November 1st, 1953.x 6,500.00 November 1st, 1954.*.1,000.00 November 1st.1955.1,000.00 November 1 st, 1956.1,000.00 November 1 st.1957.1,000.00 November 1 st, 1958.1,000.00 November 1 st.1959.1,000.00 \u2022 November 1 st.1900.1,000.00 November 1st, 1961.1,000.00 November 1st, 1902.1,000.00 November 1 st, 1903.1.000.00 November 1st, 1964.1,000.00 November 1 st, 1965.1,000.00 November 1 st, 1966.1,000.00 November 1st, 1967.1,000.00 November lst,N1968.1,000.00 November 1 st, 1969.1,000.00 The letter x indicates the years during which the yearly instalment of a total grant of $23,280.granted by the Provincial Secretary, and payable in four instalments of $5.820, each, from 1950 to 1953 inclusively, shall be received and applied to the service of this loan.Capital and interest shall be payable at the hank mentioned in the loan procedure, at Montreal, at Quebec or at Charny.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec 1941, 2410 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEllEC, Québec, 15 octobre 1949, Tome 81, N° 41 térêt, sous l'autorité «lu chapitre 212 Statuts re-\u2014subject t«> be re«leeme«l by anticipation, in whoie fondus «le Québec, 1041 ; ecjxnduiit, si tel rachat or in purt, at par, at any interest maturity date; est partiel, il affectera les échéances les plus éloi- however, in case of partial redemption, the bondi grnVs et les numéros les plus élevés.to be redeemed wdl be called for payment in reverse order of maturity and serial numl>er.Chaque soumission devra être accompagnée Each tender must he accompanied by an nc-«l'un chèque accepté égal à 1% «lu montant «le cepted che«pie equal to 1% «>f the amount of l'emprunt et devra sptvifier si le prix offert com- the loan ami must specify whether the price «if.preml ou ne compreml pus les intérêts accrus fered includes or f the tenders, missions.Daté à St-Ktienn«'-«le-Lau/.on, comté «le Dated at St-Etienne «le I,au/on.County of Levis, ce lOième jour «l'octobre 1949.Levis, this 10th of October 1949.Le Se«rétaire-trésorier, ALBERT 1)1'BOIS, 2ô933-o ALBERT DUBOIS.25933-o Secretary-Treasurer.Vente \u2014 Loi de faillite Canada, Province de Québec, District «le Québee.N° 4000-F, Cour Supérieure (En matière de faillite).Valcartier Development Inc., cédant autorisé et Jac«iues LuRue, le syndic «les biens «le la«lite compagnie Valcartier Development Inc.Avis public est, par les présentes, donné que les terrains, héritages et bâtisses ci-après décrits seront vendus en bloc, à l'enchère, en temps et lieu ci-après mentionnés et sous telles conditions telles er two hundred and forty-four (244) belonging to Valcartier Development Inc., to the south west by the dividing line between the third ami fourth ranges, to the north west by part of the said lot number two hundred and forty-two (pt.242) belonging to Monaghan or representativ«'s ami to the north east by part of lot number two hundred and forty-three (pt.243) belonging to said Valcartier Development Inc.measuring about ten (10) arpents in «lepth for the whole width «)f the said lot number two hundred and forty-three (243) and belonging to the said Monaghan or representatives; d) Lots numbers two hundred and forty-four ami two hundred ami forty-five (244 & 245).To be sold at the office of the undersigned trustee, 12(5 St.Peter Street, Quebec Citv.on NOVEMBER FIFTEENTH.1949.at ELEVEN o'clock in the forenoon.The said sale to have the effect of a Sheriff's sale.Office: \u201e JACQUES LARUE, 120 St.Peter Street, Licensed Trustee.Quebec City.25934-4l-2-o Sales by Licitation Canada, Province of Quebec, District of Beauce, Superior Court, No.20,545.Dame Antoinette Haman, plaintiff; vs Rosaire Drouin & Al, defendants.LICITATION .Notice is given that in virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at St-Joseph, in the district of Beauce, on the 22nd of Septeml>er, 1949, in a case wherein Dame Antoinette Haman, widow of Wilfrul Drouin, farmer, of St-Isidore, Dorchester, is plaintiff; and Rosaire Drouin, Jean-Marie Drouin, both of St-Isidorc, Dorchester, Gerard Drouin, of La Tuque; Emile Drouin, of Hull, Marcel Drouin an«l Philippe Drouin, both of St-Maxime, Dorchester, Robert Drouin, of Iroquois Falls, Out., ami Jean-Marie Drouin, as tutor duly an«l legally appointed to Roland Drouin, Léo Drouin, Arthur Drouin an«l Gilberte Drouin, minor children of the late Wilfrid Drouin of St-Isidore «le Dorchester, and Dame Jeanne Drouin, wife of Georges Beaudoin, farmer, of St-Isidore, and the said Georges Beaudoin, mis en cause to assist and authorize his wife for the purposes hereof, are «lcfendants; ordering the licitation of certain immovables described as follows, to wit: a) A farm situate in the said parish of St-Isidore, east of the Justinienne road, measuring three arpents in front by thirty arpents in depth, the whole more or less \u2014 with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, known on the official cadastral plan and in the book of reference for the said parish of St-Isidore, as number five bundre and fifty-six (556).6) A parcel of land situate in the parish of St-Maxime, West Justinienne concession, measuring one arpent and one half in front by ten arpents 2412 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 15 octobre 191*9, Tome 81, N° 1*1 pents «le profomleur, borné vers le nord au lot numéro trois cent quatre-vingt-un, vers le sud au lot numéro 379 du cadastre de St-Isidore, vers l'ouest à CJeorges Nadeau, et vers l'est à André l'on lin, circonstances et dépendances, lequel terrain fait partie du numéro trois cent quatre vingt (p 3X0) des plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour ladite paroisse de St-Isidore, faisant maintenant partie de St-Maxime; c) D'un morceau de terrain de forme triangulaire situé en ladite paroisse de St-Isidore, à l'ouest de la route Justinienne, partant à un point sur la route qui conduit au chemin du (.rami Rang et allant en élargissant vers le sud et jusqu'à une longueur de sept arpents et demi où ledit terrain vendu aura une largeur de deux arpents, deux perches et trois quart, borné vers le sud-ouest à ladite route qui conduit au Grand Rang, vers le nord-est au numéro 404 du cadastre susdit et vers le sud-est à Georges Boutin, circonstances et dépendances, lequel terrain fait partie du numéro quatre cent trois (403) des plan et livre de renvoi officiels dudit cadastre de St-Isidore ; d) D'un autre morceau de terrain situé en ladite paroisse de St-Maxime, à l'ouest de la route Justinienne, contenant un arpent de largeur, sur neuf arpents de trois perches de profondeur, plus ou moins, quant à la profondeur, borné en front vers l'est à André Poulin à l'endroit communément appelé \"désert\" vers l'ouest à Valère et Joseph Rhéaume.d'un côté vers le nord à Joseph Z.Parent et de l'autre côté vers le sud à Eloi Bouffard, lequel terrain fait partie des lots numéros trois cent quatre-vingt-trois et trois cent quatre-vingt-quatre (383 & 384) des plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour ladite paroisse de St-Isidore faisant, maintenant partie de St-Maxime; Les immeubles ci-dessus désignés seront mis à l'enchère et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur le QUINZIEME jour de NOVEMBRE prochain, à DIX heures de l'avant-midi, cour tenante, dans la salle d'audience du palais de justice de la cité de St-Joseph, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite cour; et toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou afin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du pronotaire de ladite cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et toute opposition a fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits, elles seront forcloses du droit de le faire.St-Joseph de Beauce, le 29 septembre 1949.Le Procureur de la demanderesse, 25869-40-2-O ROSAIRE BEAUDOIN.Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 270802.Dame Réjane Poirier, demanderesse; vs Roméo Farah La joie, défendeur.AVIS DE LICITATION Avis est par les présentes donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Montréal, dans le «listrict de Montréal, le 23 juin 1949, dans une cause portant le N° 270802 de ladite Cour, dans laquelle Dame Réjane Poirier, épouse contractuellement séparée de biens de Jean Marie CorbeiL courtier en assurances, in depth, bounded on the north by lot number three hundred and eighty-one, on the south by lot number 379 of the cadastre for St-Isidorè, on the west by Georges Nadeau, and on the east by André Poulin\u2014circumstances and dependencies, the said parcel of land forms part of number three humlreti and eighty (Pt.380) on the official cadastral plan and in the book of reference for the said parish of St-Isidore, now forming part of St-Maxime; c) A pared of land of triangular figure situate in the said parish of St-Isidore, west of the Justinienne road, starting at a point of the road leading to the ''Grand Rang\" roa«l an«l widening as it runs towards the south and on a length of seven ami one half arpents where the said parcel of land sold has a width of two arpents, two and three «piarter perches, bounded on the southwest by the said road leading to the \"Grand Rang\", on the northeast by number 404 of the aforesaid cadastre and on the southeast by Georges Boutin\u2014circumstances and dependencies, the said parcel of land forms part of number four hundred and three (403) on the official cadastral plan ami in the book of reference for St-Isidore; d) Another parcel of land situate in the said parish of St-Maxime, west of the Justinienne road, measuring one anient in width by nine arpents ami three perches in depth, more or less, as to «lepth; bounded in front on the east by André Poulin at the place commonly called \"désert'*, on the west by Valère and Joseph Rhéaume, on one side to the north by Joseph Z.Parent ami on the other si«lc to the south by Eloi Bouffard, the said lot of land forms part of lots numbers three hundred and eighty-three and three hundred and eighty-four (383 & 384) on the official cadastral plan in the book of reference for the said parish of St-Isidore, now forming part of St-Maxime; The above described immovables will be sold by auction an«l adjudged to the highest and last bidder on the FIFTEENTH day of NOVEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon, sitting the Court, in the Court Room of the Court House in the city of St-Joseph, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the said Court; and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation, must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; and, failing the parties to fiie the said oppositions within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.St-Joseph de Beauce, September 29, 1949.ROSAIRE BEAUDOIN, 25869-40-2 Attorney for plaintiff.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court No.270802 Dame Réjane Poirier, plaintiff; vs Roméo Farah La joie, defendant.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at Montreal, district of Montreal, on the 23rd day of June, 1949, in a case bearing No.270802 of the said Court, wherein Dame Rejane Poirier, wife separate as to property by marriage contract of Jean Marie Corbeil, insurance broker, with whom QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 15th, 191*9, Vol.81, No.U 2413 avec lequel elle demeure ù Montreal, dit «listrict, et dûment autoris»'* par ee dernier est dcniande-resse et Romeo Farah I.ajoie, gérant, «le Mont-réu!, dit district, est défendeur, ordonnant la licitution des immeubles «lésigm's comme suit: 1° \"lTn lot «le terre ou emplacement situé sur la rue Des Erables, en la cité «le Montréal, composé du lot «le terre numéro un «le lu re-suhilivision officielle «lu lot numéro cimj cent dix «le la re«livision officielle «lu lot originaire numéro doUM (12-510-1), et du lot «le terre numéro «leux «le la resubdivision officielle «lu lot numéro cin«i cent neuf «le la redivision officielle dudit lot originaire numéro douze (12-500-2) tous deux «lu même cadastre du Village de la ( ote de lu Visitation, contenant ledit emplacement vingt-cinq (Hftdl de largeur sur «piatre-vingt-sept pieds de profomleur, plus ou moins, nu'sure anglaise.Avec droit de passage «lans la nu-Ile située en arrière, aux conditions ordinaires d'entretien.Avec les bâtisses construites sur ledit emplacement et notamment la maison contenant trois logements portant les numéros 4X11.4X13 et 4815 de la«lite rue «les Erables, les murs latéraux «lesdites bâtisses étant mitoyens «les deux côtt'vs et le droit «le mitoyenneté dans le mur siul-est ayant été réservé par l'auteur des vendeurs.\" 2° \"Un lot de terre ou emplacement ayant front sur la nie «les Érables, en lu cité de Montréal, composé des lots «le terre connus et désignés sous le numéro un «le lu resubdivision officielle du lot numéro cinq cent onze «le la redivision officielle du lot originaire numéro douse (12-511- 1).et sous le numéro «leux «le la resubdivision officielle du lot numéro cinq cent dix de lu redivision officielle du lot originaire numéro doues (12-510-2) au ca«lastre du village «le la Cote «le la Visitation, contenant ledit emplacement vingt -quatre pieds de largeur sur quatre-vingt-sept pie«ls de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise.Avec droit de passage «lans la ruelle située en arrière, aux conditions ordinaires d'entretien.Avec les bâtisses construites sur lof lit emplacement et notamment la maison contenant trois logements portant les numéros 4817, 4817a et 4819 de la rue Des Érables les murs latéraux «lesdites bâtisses étant mitoyens «les «leux côtés.*' 3° \"Un lot de terre ou emplacement ayant front sur la rue Des Érables, en la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro deux «le la resubdivision officielle du lot numéro cinq cent onze de la redivision officielle du lot originaire numéro douze (12-511-2) au ca«lastre du village «le la Cote de la Visitation, contenant vingt -quatre pieds de largeur sur quatre-vingt-sept pieds de profondeur, plus ou moins mesure anglaise.Avec droit de passage dans la ruelle située en arrière, aux conditions ordinaires d'entretien.Avec aussi les bâtisses construites sur ledit emplacement et notamment la maison contenant trois logements portant les numéros 4821, 4821a et 4823 de la rue Des Érables, les murs latéraux des dites bâtisses étant motoyens des deux côté-.\" 4° \"Un lot de terre ayant front sur la nie Des Érables, en la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro cinq cent douze de la redivision officielle du lot originaire numéro douze (12-512) au cadastre du village de la Côte de la Visitation, contenant ledit lot vingt-cinq pieds de largeur sur quatre-vingt-sept pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise.Avec droit de passage dans la ruelle située en arrière aux conditions ordinaires d'entretien.she lives in Montreal, said «listrict, and duly authorised by the latter, is plaintiff; and Roméo Farah i .a joie, manager, Montreal, sai«l district, is defendant, ordering the licitation of the immovables described as follows: 1.A lot of land or emplacement situate on Des Érables street, in the city of Montreal, composed of the lot of land number one of the official resubdivision of lot number five hundred and ten of the officiul redivision of original lot number twelve (12-510-1), ami the lot of land number two of the official resubdivision of lot number five hundred and nine of the official redivision of said original lot number twelve (12-509-2) both of the same cadastre for the for the Village of (ote «le la Visitation, the said emplacement measuring twenty-five feet in width by eighty-seven feet in depth, more or less, English measure.With right of way in the lane situate in rear of same, umler usual conditions of maintenance.With the buildings erected on the said emplacement ami in particular the house containing three dwellings bearing numbers 4811, 4813 ami 4X15 of sai«l des Érables street, the side walls of said buildings being \"mitoyens\" on both sides ami right of \"mitoyenneté\" in the southeast wall having been reserve» 1 by the auteur of the vendors.2.A lot of land or emplacement fronting on Des Érables street, in the city of Montreal, composed of the lots of laud known and designat-c«l under number one of the official resubdivision «)f lot number five hundred ami eleven of the official redivision of original l«>t number twelve (12-511-1) ami under number two of the official resubdivision of lot number five hundred and ten of the official re, 4827 et 4829 de la dite rue Des Érables.Avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes attachées audit immeuble et notamment celle en vertu de laquelle toutes portes, fenêtres ou ouvertures et cheminées existant actuellement «lans et sur les bâtisses construites sur les lots numéros cin«| cent «louze et cinq cent treize «le lu «lite re«livision du lot originaire numéro «louze (12-512 & 513) noteront telles qu'elle! sont actuellement, et ce en vertu «l'un acte «lY'tablissement de servitmle fait entre Joseph et Edmond Mean parla ml et Alexandre Tousignant, «levant Me J.M.Savignac, notaire, le trente-et-un décembre mil neuf cent vingt-huit et enregistré à Montréal ROUI le numéro 200292.\" 5° \"Un lot «le terre ou emplacement ayant front sur la rue Des Érables, en la Cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro einq eent seize «le la redivision officielle «lu lot originaire numéro douze (12-510) au cadastre «lu village «le la Côte de la Visitation, contenant vingt-cinq pieds de largeur sur TIA va THE ( VA)R-GE M.BRUNTON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.1.Lei subdivisions Nos 2 (deux), 3 (trois), 4 (quatre), » (cinq), (i (six).7 (sept).8 (huit).9 (neuf).10 (dix).11 (onze), 12 (douze).13 (treize), 14 (quatorze), 15 (quinze).10 (seize), 17 (dix-sept), IS (dix-huit).19 (dix-neuf).20 (vingt).21 (vhigt-et-un), 22 (vingt-deux).23 (vingt-trois).24 (vingt-quatre), 25 (vingt-cinq), 20 (vingt-six), 27 (vingt-sept), 28 (vingt-huit).29 (vingt-neuf).30 (trente).31 (trente-et-un).32 (trente-deux).33 (treide-trois).34 (trente-quatre), 35 (trente-cinq), 36 (trente-six), 37 (trente-sept).38 (trente-huit), 39 (trente-neuf).40 (quarante), 41 (quarante-et-un) 42 (quarante-deux), 43 (quarante-trois), 44 (quarante-quatre), 45 (quarante-cinq), 40 (quarante-six), 47 (quarante-sept), 48 (quarante-huit).49 (quarante-neuf), 50 (cinquante), 51 (cinquante-et-un), 52 (cinquante-deux), 53 (cinquante-trois), 54 (cinquante-quatre) 55 (cinquante-cinq), 50 (cinquante-six).57 (cinquante-sept), 58 (cinquante-huit), 59 (cinquante-neuf).00 (soixante), 01 (soixunte-et-un), 02 soixante-deux), 03 (soixante-trois).04 (soixante-quatre), 65 (soixante-cinq), 00 (soixante-six), 07 (soixante-sept), 68 (soixante-huit), 69b (soixante-neuf B).70b (soixante-dix B) et 71 (soixante-et-onze) du lot N° 085 (six cent quatre vingt-cinq) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Catherine, comté -de Portneuf, étant des lots situés au Lac St-Joseph.2.La partie non subdivisée de cette partie du dit lot N° 585 (cinq cent quatre-vingt-cinq) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Cathe-rine étant un lot de terre compris entre le Lac St-Joseph et le Chemin Public, borné au sud-ouest par le Lac St-Joseph.au nord-est par le chemin public, au nord-ouest par le lot N° 086 et au sud-est par le lot N° 684; sauf à distraire de ladite partie un lopin borné en front au Lac St-.Joseph et y mesurant 42 pieds de largeur par 70 pieds de profondeur et bornée d'un côté au lot N° 684 et de l'autre côté en arrière au résidu du dit lot N° 685.3.Partie du lot N° 684 (six cent quatre-vingt-quatre) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Catherine, comté de Portneuf, étant un lopin de terre de forme triangulaire situé au Lac St-Joseph.borné au nord-ouest au lot N° 685, au nord-est par le chemin public et sud-ouest par une ligne tirée à quatre-vingt pieds anglais de la pointe du triangle.4.Partie du lot N° 684 (six cent quatre-vingt-quatre) du cadastre officiel pour la paroisse de Roy Lusk, heretofore of the township of Eardlcv and actually of Fort Coulonge, and the said Buy Lusk, to authorize his wife for the purposes hereof , defendant.Lot number five (5) of the fifth rungc of the township Eardlcy \u2014 with ull the buildings thereon erected.To be sold, at the parochial church door of St-Dominique de Luskville, on the TWENTY-FOURTH of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.(Daylight Saving Time).I.ST-PIERRE, Sheriff's Office, Sheriff.Hull, September 17.1949.25785-38-2 [First insertion: September 24, 1949] QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : i THE BANK OF NOVA S.C.57.01 I j SCOTIA vs THE GEORGE M.BRUNTON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.1.Subdivisions numbers two (2).three (3), four (4).five (5), six (6).seven (7), eight (S), nine (9).ten (10).eleven (11).twelve (12).thirteen (13).fourteen (14).fifteen (15).sixteen (10).seventeen (17), eighteen (18), nineteen (19).twenty (20), twenty-one (21), twenty-two (22).twenty-three (23).twenty-four (24).twenty-five (25).twenty-six (20).twenty-seven (27).twenty-eight (28), twenty-nine (29), thirty (30), thirt'v-one (31).thirty-two (32), thirty-three (33).thirty-four (31).thirty-five (35), thirty-six (30), tnirty-seven (37).thirty-eight (38), thirty-nine (39).* forty (40).forty-one (41), forty-two (12).forty-three (43).forty-four (44).forty-five (45).fortv-six (46).forty-seven (47).forty-eight (4K).fortv-nine (49).fifty (50), fifty-one (51), fiftv-two (52).fifty-three (53).fifty-four (54).fifty-five (55), fifty-six (50).fifty-seven (57), fifty-eight (58), fifty-nine (59), sixty ((50).sixty-one (01).sixty-two (62).sixty-three (63), sixty-four (64), sixty-five (65).sixty-six (06), sixty-seven (67), sixty-eight (OH), sixty-nine B (09b).seventy B (70b) ami seventy-one (71) of lot six hundred and eighty-five (685).of the official cadastre for the parish of Ste-Catherine, county of Portneuf, being lots situate at Lake St.Joseph.2.The unsubdivided part of that part of said lot number five hundred and eighty-five (No.585) on the official cadastre for the parish of Ste-Catherine.being a lot of land contained between Lake St.Joseph and the Public Road, bounded on the southwest by Lake St.Joseph on the northeast by the public road, onthe northwest by lot No.\" 080 and on the southeast by lot No.684.save to be deducted from the said part, a parcel of land bounded in front by Lake St.Joseph and measuring 42 feet in width by 70 feet in depth and bounded on one side by lot No.684 and on the other side and in rear by the residue of said lot No.685.3.Part of lot number six hundred and eighty-four (No.684) on the official cadastre for the parish of Ste-Catherine, county of Portneuf, being a parcel of land of triangular figure situate at Lake St.Joseph, bounded on the northwest by lot No.685, on the northeast by the public road and on the southwest by a line drawn at eighty feet, English measure, from the point of the triangle.4.Part of lot number six hundred and eighty-four (No.684) on the official cadastre for the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lôth, 101*9, Vol.81, \\o.1*1 2417 str-< atherine, eonté «le Portneuf, étant un lot dfl tefTf situé au Lac St-Joseph, mesurant 27H niedl «le front par (100 pieds de profondeur, borné à l'ouest au «lit l«>t N\" 680 «t th'.s autres f said lot No.084, the north line being «Iruwn at 710 feet from the «livision line of .-aid l«»t No.08-1; the whole with right of way in common with others over a strip «»f land 12 mat wide starte«l from the purt above described and running to lake St.Joseph, along the northwest line of said lot No.084.The immovable described in the secoml paragraph and the subdivisions Nos.55, 50 und 71 described in the first paragraph, being subject to servitudes of passage, electric lines and no building.The whole to l>e sohl \"en bloc\".To l)o sohl \"en bloc\" at the parochial church door of Ste-Catherine, countv of Portneuf, on the EIGHTEENTH day of NOVEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.AIME DION, SherhTs Office, Sheriff.Quebec, October 12.1949.25908-41-2 [First insertion: October 15.1949] [Secoml insertion: October 29, 1949] SAINT-FRANCIS Fieri Facias de Terris Magistrate's Court Province of Quebec, ( p IE D'ASSURANCE District of J ^ CANADIENNE St.Hyacint he.) M ERCANTILE, body po-No.11751 ' litic and incorporated, legally constituted, having its head office and place of business in the city ami «listrict of St.Hyacinthe, plaintiff, vs LUCIEN TARDIF, of Victo-riaville, district of Arthabaska, defendant.As belonging to the said «lefendant: 1.A piece of ground known umler the number thirty-five upon the official cadastral plan for the village of Beaidac, with all the buildings thereon erccte«l, circumstances and dependencies, servitudes active and passive, apparent or occult at-tached thereto.2.A piece of land known as being part of lot number thirty-six (P.30) of the official cadastral plan for the village of Beaulac, measuring three feet in width on Arohambault street, which bounds it in front by twenty-one feet and a half in depth, forming a superficy of sixty-five feet, bounded on the southeast side by the number thirty-five, in rear to the southwest and on the northwest side by the residue of said number thirty-six, with circumstances and dependencies.3.A building measuring about ten feet by twenty feet, erected on the north part of lot mini* ber thirty-three (P.North 33), on the official cadastral plan for the village of Beaulac.\" To he sold \"en bloc\" at the tloor of the parochial church of St.Charles Borromée de Garthby (Beaulac), on the NINETEENTH of NOVEMBER 1949, at 10.30 o'clock in the forenoon (stan-«lard time).J.P.C.LEMIEUX, Sheriffs Office.Sheriff.Sherbrooke, October the 6th, 1949.25909-4 l-2-o [First insertion: October 15th, 1949] SAINT-HYACINTHE Fieri Facias dc Bonis et de Terris Cour «le Magistrat, fXTESTOR LAVI- Magistrate's Court, (XJ District de St-Hyacinthe.\\ GNE, cultiva- District of St-Hyacinthe, < ^ GNE, farmer, N° 11819.'teur, «le Saint-Simon No.11819.' of Saint-Simon de SAINT-HYACINTHE Fieri Facias de Bonis et de Terris [agistrate^s Court, (J^TESTOR LAVI- 2418 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 octobre 1949, Tome 81, N° 41 de Bagot, «listrict «le Saint-Hvwiuthe, demandeur Bagot, district of Saint-Hyacinthe, plaintiff, vs vs ROLLAND MAR'PEL, cultivateur et camion- HOLLAND MARTEL, farmer ami carter, o neur «le Saint-Liboire, district «le Saint-Hyaciu- Saint-Lihoirc, district of Saint-Hyacinthe, defen th«', défemleur.daut.SuLsies comme appartenant au défendeur.Seized as belonging to the defendant; 1.Une terre située eu la paroisse «le Saint-Li- I.A farm situute in the parish of Saiut-I,i boire, sur le rang Saint-Patrick, étant le lot nu- boire, in the Saint-Patrick range, being lot nuin nmrodcux cent vingt-six (22(5) du catlustre officiel her two hundred and twenty-six (220) of the «,fli-de la paroisse de Saint-Lihoirc, comté de Bagot, cial cadastre for the parish of Saint-Liboirc, «le la contenance «le «leux arpents de largeur par county of Bugot, measuring two arpent.s in width vhigtyet-uii irpeotl de profomleur, plus ou moins, by twenty-one arpents in depth, more Qf lest, ayant une su|>erficie d'environ «piarantc-deux ar- having a su|K'rficial area of about forty-two ai petits, bornée en front par le chemin public, en petits, l>ouiif the Saint-Georges range, du c«A)té nord-ouest par le lot numéro «leux cent ou the northwest side by lot number two hundred vingt-cimj appartenant à Lucien Montinanpiette, and twenty-five, belonging to Lucien Montinar-et du «\"«\"ité sud-est par le lot numéro «leux cent QJUOttO, ami on the southeast si«le by lot number vingt-sept appartenant à Daine Napoléon Blan- two hundred ami twenty-seven belonging to Da-chard.Avec bâtisses y dessus érigées.nu?Napoléon Blanchard.With buildings thereon erected.2.l^ne terre située en la paroisse «le Saint-Li- 2.A farm situate in the parish of Saint-Liboire, boire, sur le rang Saint-Patrick, étant le lot nu- in the Saint Patrick range, being lot number two méro «leux cent trente (230) du cadastre officiel hundred ami thirty (230) of the official cadastre «le la paroisse «le Saint-Liboirc, comté «le Bagot, for the parish of Saint-Liboire, county of Bagot.«le la contenance «le «leux arpents «le largeur par measuring two arpents in width by twenty-one vingt-et-un arpents de profomleur, plus ou moins, arpents in «lepth, more or less, having a super-ayant une superficie d'environ «piuraute-deux ar- ficial area of about forty-two arpents, bounded in pent-, bornée en front par le chemin public, en front by the public road, in «lepth by the lands profomleur par les terres «lu rang Suint-Georges, of the Saint-Georges range, on the northwest side du côté nord-ouest par le lot numéro «leux cent by lot numlter two hundred and twenty-nine be-vingt-neuf appartenant à Emilien Blanchette, et longing to Kinilien Blanchette, and on the south- Robert Blanchette.With bâtisses y dessus érig«'?es.buildings thereon erected.Pour être vendues à la porte «le 1 église parois- To l>e sohl at the parochial church door of siale «le Saint-Liboire, comté «le Bagot.le DIX- Saint-Liboirc, county of Bagot, on the NINE-NEUVIEME jour de NOVEMBRE 1949, à TEENTH day of NOVEMBER, 1949, at TEX DIX heures «le 1'avant-midi.o'clock in the forenoon.Le Shérif, RICHARD BOUSQUET, Bureau «lu Shérif, RICHARD BOUSQUET.Sheriff's Office, Sheriff.St-Hyacinthe, le 12 octobre 1949.25928-41-2-c St-Hyacinthe, October 12, 1949 2.5928-41-2 (Premiere insertion : 15 octobre 1949] [First insertion : Octol>er 15, 1949] Index de la Gazette officielle Index of the Quebec Official de Québec, N° 41 Gazette, No.41 Avis aux intéressés: 2373 Notice to Interested Parties: 2373 Avis divers: Miscellaneous Notices: Alberto Inc.(Directeurs) .2392 American Paper Box Co.Limited (Directeurs).2392 C.Champoux Inc.(Distribution dc l'actif).\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 2392 Domestic Electric Limited (Distribution de l'actif).2390 La Caisse Populaire de Breakeyville (Fondation).2391 L'Association -Canadienne d'Urbanisme, \u2014 Division de la Province de Québec \u2014 The Community Planning Association of Canada \u2014 Quebec Provincial Division (Directeurs).'.2391 Le Syndicat National Catholique des Employés «le l'Industrie «lu Cuir et «le la Chaussure des Trois-Rivières Inc.(Existence terminée).2391 Mégantie, ville de (Construction d'un barrage).2390 Romaine River Railway Company (Directeurs).2391 The Arvida Athletic & Recreation (A.A.R.A.) (Changement de nom).2390 Alberto Inc.(Directors).2392 American Paper Box.Co.Limited (Directors).2392 C.Champoux Inc.(Distribution of the assets).2392 Domestic Electric Limited (Distribution of the assets).2390 La Caisse Populaire de Breakeyville (Foundation).____ 2391 L'Association Canadienne d'Urbanisme, \u2014 Division de la Province de Quél>cc \u2014 The Community Planning Associa tion of Canada \u2014 Quelle Provincial Division (Directors).2391 Le Syndicat National Catholique des Employés de l'Industrie du Cuir et de la Chaussure des Trois-Rivières Inc.(Existence terminated).2391 Megantic, town of (Construction of a dam).2390 Romaine River Railway Company (Directors).2391 The Arvida Athletic & Recreation Association (A.A.R.A.) (Change of name) 2390 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October loth, 191*9, Vol.81, No.1*1 2419 ( oMI'AONIES A I I'OKISl'.KS A FAME DKS \\ i i \\ 11(l-.s : I'red Maimix & Compuny Limited.lames Buy South, Ineor|M>ruted.DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DKS: A I-1'Al H es M un i Cl l'A les : Lotbinière, village de.SI-Maxime du Mont-Louis, munie, de A'HML'LTUliE: Dissolution de cercles agricoles dans le comté de Montmorency.Dissolution de cercles agricoles dans le comté de Québec.Dissolution de cercles agricoles dans le comté de ltouville.Dissolution de cercles agricoles dans le comté de Saguenay.A'.ni
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.