Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 5 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1949-11-05, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 81, N# 44 2517 Vol.81, No.44 \t\t \t\t1 \t\t i\t\t \t\t (Drapeau de la province de Québec, adopté par arrêté en conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flag of the Province of Quebec, adopted by Order in Council Number 72, bearing date January 21at, 1948) Gazette officielle de Québec (PUBUÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBUSHED BY THE PROVINCIAL GOVERN MENT) PROVINCE DE QUÉBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 5 novembre 1949\tQuebec, Saturday, November 5th, 1949 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.- L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion : otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme without prejudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are \u2022ont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-claase, Ministère dee Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 2518 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 1919, Tome 81, N° U délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication «le certains documents, à euuse de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui «le l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hotel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.23879 \u20141-52 Lettres patentes Alliance Advertising & Applied Arts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept septembre 1949, constituant en corporation: Marcel Lajeune.sse, avocat, de la cité de Westmount, Gaston Pouliot, Marcel Robi-taille, avocats, Alcide Grenon.comptable, et Thérèse Jolette, sténographe, fille majeure, tous quatre de la cité de Montréal, tous du distiict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agents et conseillers en publicité, sous le nom de \"Alliance Advertising & Applied Arts Inc.\" Le capital de la compagnie est divisé en 1.C00 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant du capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $5,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs-day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain «Inclinants, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to a«lvisc the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: Si.per do/en.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third tlie number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.23879 \u20141-52 letters Patent Alliance Advertising & Applied Arts Inc.Notice is hereby given that under Part I of tlie Quebec Companies Act.letters patent have been bsued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of September, 1949, incorporating: Marcel Lajeunesse, advocate, of the city of Westmount, Gaston Pouliot, Marcel Robitaille.advocates, Alcide Grenon, accountant, and Thérèse Jolette, stenographer, spinster, all four of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act in the capacity of advertising agents and counsel, under the name of \"Alliance Advertising & Applied Arts Inc.\" The capital stock of the company is divided into 1,000 shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be S5.000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.November 6th, 19A9, Vol.81, No.U 2519 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 2G014 L.DÊSILETS.American Spring Manufacturers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit septembre 1949, constituant en corporation: Louis Tessler, Bennie Tcssler, manufacturiers, et John Sehlesinger, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers de ressorti de lits, rembourreurs et marchands de meubles, sous le nom de \"American Spring Manufacturers Ltd.\", avec un capital de 325,000 divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 1.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 2G014 L.DÊSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of September, 1949.L.DÊSILETS, 20014-o Deputy Attorney General.American Spring Manufacturers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bcuring date the twenty-eighth day of September, 1949, incorporating: Louis Tessler, Bennie Tessler, manufacturers, and John Sehlesinger, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as bed spring manufacturers, upholsterers, furniture dealers, under the name of \"American Spring Manufacturers Ltd.\", with a capital stock of $25.000 divided into 1,500 common shares of $10 each, and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014-o Deputy Attorney General.Her hard & Fortier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois septembre, 1949, constituant en corporation: Aurèlc Béchard, soudeur, Albert Fortier, machiniste, tous deux de Ste-Claire, et Roland Fortier, cultivateur, de St-IIcnri, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire tous genres de réparations à des moteurs; Exercer la profession de soudeur, sous le nom de \"Béchard & Fortier Inc.\", avec un capital de S20.000 divisé en 360 actions privilégiées de $50 chacune, et 40 actions ordinaires de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Claire, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 20014-o L.DÊSILETS.Béchard & Fortier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of September, 1949, incorporating: Aurèle Béchard, welder, Albert Fortier, machinist, both of Ste-Claire, and Roland Fortier, farmer, of St-Henri, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To undertake all kinds of repairs to motors; To carry on the trade of welder, under the name of \"Béchard & Fortier Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 360 preferred shares of $50 each, and 40 common shares of $50 each.The head office of the company will be at Sainte-Claire, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014 Deputy Attorney General.Citadel Realty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six septembre 1949, constituant en corporation: Sydney Lazarovitz, François Veilleux, avocats, et Madeleine Bilodeau, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Acquérir et disposer de propriétés et de tous intérêts en icelles et entreprendre la construction la réparation, l'amélioration et la rénovation de propriétés immobilières, sous le nom de \"Citadel Realty Co.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26014 L.DÊSILETS.Citadel Realty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of September, 1949, incorporating: Sydney Lazarovitz, François Veilleux, advocates, and Madeleine Bilodeau, stenographer, spinster, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To acquire and dispose of property and any interest therein, and to engage in the construction, repair, improvement and renovation of immoveable property, under the name of \"Citadel Realty Co.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.- The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014-o Deputy Attorney General. 2520 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 19A9, Tome 81, N° U Dakar Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-trois septembre 1949, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en Loi du Roi, Beatrice Rabinovitch, secrétaire, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, et Theodore H.Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, détenir et posséder un certain emplacement ayant front sur les rues St-Nicholas, St-Paul et Lemoyne, en la cité de Montréal, sous le nom de \"Dakar Corp.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26014 L.DÊSILETS.E.Beaudoin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente septembre 1949, constituant en corporation: Anna Stella Bourdon, veuve d'Ernest Beaudoin, ménagère, Albert Beaudoin, gérant, et Roland-R.Beaudry, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre les cuirs de toutes sortes, et tous articles en cuir ou dérivés de ce produit, sous le nom de \"E.Beaudoin Inc.\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26014-o L.DÊSILETS.Fraser Realty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six septembre 1949, constituant en corporation: Sydney Lazarovitz, François Veilleux, avocats, et Madeleine Bilodeau, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Acquérir et disposer de propriétés et de tous intérêts en icelles et entreprendre la construction, la réparâti< n.1 amélioration et la rénovation de propriétés mmobilières, sous le nom de \"Fraser Realty Co.\", avec un capital de $49,000 divisé en 490 actions de $100 chacune.Le siège soci d de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six septembre 1949.' L'Assistant-procureur général, 26014 L.DÊSILETS.Gagnon and Thibault Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Dakar Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of September, 1949, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Beatrice Rabinovitch, secretary, spinster, both of the City of Montreal, and Theodore H.Shapiro, advocate, of the Town of Mount-Royal, all in the Judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and to hold and own a certain emplacement fronting on St.Nicholas St., St.Paul St., and Lemoyne St.in the city of Montreal, under the name of \"Dakar Corp.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $100 each.The beat! office of the Company will be at Montreal, Judiciul District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014-o Deputy Attorney General.E.Beaudoin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of September, 1949, incorporating Anna Stella Bourdon, housewife of Ernest Beaudoin, Albert Beaudoin, manager, and Roland R.Beaudry, chartered accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: * To purchase, sell, leather of every kind, and any articles made of leather or derived from this product, under the name of \"E.Beaudoin Inc.\" with a capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014 Deputy Attorney General.Fraser Realty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of September, 1949, incorporating: Sydney Lazarovitz, François Veilleux, advocates, and Madeleine Bilodeau, stenographer, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes : To acquire and dispose of property and any interest therein, and to engage in the construction, repair, improvement and renovation of immoveable property, under the name of \"Fraser Realty Co.\", with a capital stock of $49,000 divided into 490 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014-o Deputy Attorney General.Gagnon and Thibault Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 6th, 19A9, Vol.81, No.U 2521 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit septembre 1949, constituant en corporation: Arsène Gagnon, chauffeur de taxi,Maurice Thibault, camionneur, tous deux de la ville de Duparquet, district judiciaire d'Abitibi et Richard Wesley Taylor, comptable, de la ci té de No-randa, district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants: Exercer un commerce de camionnage et de transport ; faire le commerce de charbon, bois de chauffage et autres combustibles; effectuer des travaux d'excavation et autres choses semblables sous le nom de \"Gagnon and Thibault Ltd.\", a\\roperty by marriage contract of said Rodrigue foly, both of the city of Outremont, and Marc Leroux, notary, of the Town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To manufacture and deal in dry-goods, textiles, haberdashery, footwear, household furnishings, tailors trimmings, under the name of \"Tailleurs Joly Inc.\"\u2014\"(Joly Tailors Inc.)\", with a capital stock of $150,000, divided into 500 common shares of $100 each and 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General,, this thirtieth day of September.1949.L.DÊSILETS, 26014 Deputy Attorney General.The Lauren tide Dairy Products Corporation La Corporation des Produits Laitiers Laurcntide Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of September, 1949, incorporating: Robert Lafleur, advocate, Marcelle Flamand, stenographer, spinster, both of the city of Outremont, and Marcel Gaboury, advocate, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in milk and all products and by-products derived from milk; and in all food products, under the name of \"The Laurentide Dairy Products Corporation\" \u2014 \" La Corporation des Produits Laitiers Laurentide\", with a capital stock of $500,000 divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 19,600 preferred shares of a par value of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014 Deputy Attorney General.Turcotte Lumber Val d'Or Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of September, 1949, incorporating: Lorenzo Turcotte, industrialist, Albert Turcotte, foreman, and J.Arthur Gagnon, accountant, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on business as lumber merchants and dealers in building requisites, under the name of \"Turcotte Lumber Val d'Or Limited\", with a capital stock of $200,000 divided into 2000 shares of $100 each. 2528 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 19A9, Tome 81, N° U Le siège de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26014-o L.DÊSILETS.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of September, 1949.L.DÊSILETS, 2G014 Deputy Attorney General.Yale Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf septembre 1949, constituant en corporation: Bernard Diamond, Louis Orenstein et Bernard S.Mergler, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de terrains, immeubles, bâtisses et propriétés immobilières de toutes sortes, sous le nom de \"Yale Holdings Ltd.\", avec un capital de $200.000 divisé en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera â 3486 avenue Park, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26014 L.DÊSILETS.Yale Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of September, 1949, incorporating: Bernard Diamond, Louis Orenstein and Bernard S.Mergler, advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in lands, real estate, buildings and immoveable property1 of all kinds, under the name of \"Yale Holdings Ltd,\", with a capital stock of $200,000.divided into 1,000 preferred shares of $100.each, and 1,000 common shares of $100 each.The head office of the Company will be at 3486 Park Avenue, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General-this twenty-ninth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26014-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Aldo Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 octobre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Algiers Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 juin 1947, en celui de \"Aldo Restaurant Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 19 octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.Aldo Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the nineteenth day of September.1949, changing the name of the company \"Algiers Inc.\", incorporated by letters patent dated June 25th, 1947, to that of \"Aldo Restaurant Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Autobus Sagucnay, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 septembre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Autobus et Taxis, Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 juillet 1925, en celui de Autobus Saguenay, Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 19 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.Autobus Saguenay, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the nineteenth day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Autobus et Taxis, Limitée\", incorporated by letters patent dated July 24th, 1925, to that of \"Autobus Saguenay, Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of September, 1949.L.DÊSLLETS, 26015 Deputy Attorney General.Chardo Industries Limited Les Industries Chardo, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplé- Chardo Industries Limited Les Industries Chardo, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the sixth day of October, 1949, were issued by the Lieutenant- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 6th, 19A9, Vol.81, No.U 2529 incut aires, en date du 6 octobre 1049, à la compagnie \"Chardo Silverware, Ltd\"\u2014\"La Com-pugnie d'Argenterie Chardo, Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 7 juin 1946, sous le nom de \"Chardo, Ltd\"\u2014 \"Chardo, Ltée\", et par lettres patentes supplémentaires en date du 6 décembre 1948, changeant ce dernier nom au nom susdit de \"Chardo Silverware, Ltd\"\u2014\"La Compagnie d'Argenterie Chardo, Ltée\", changeant de nouveau son nom en celui de \"Chardo Industries Limited\"\u2014 \"Les Industries Chardo, Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le 6 octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 2601 ô-o L.DÊSILETS.Gatineau Lumber & Builders Supply Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 15 septembre 1949, à la compagnie \"Gatineau Lumber & Builders Supply Ltd.\", ratifiant son règlement N° 1A augmentant son capital-actions de 150,000 à $100,000 par la création de 500 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 15 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.Hinda Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du onze octobre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Hinda Chenilles Incorporât' i\", incorporée par lettres patentes en date du 2 mai 1947, en celui de \"Hinda Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le onze octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015 ' L.DÊSILETS.La Compagnie C.A.Cayouette Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-riwet, conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi S.R.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 septembre 1949, à la compagnie \"La Compagnie C.A.Cayouette Limitée\", ratifiant son règlement N° 21 étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le 26 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.Ladies' Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Nachlas Zkeinim Inc.(Ladies' Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Home for the Aged Inc.) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt-neuf septembre Governor of the Province of Quebec, to the company \"Chardo Silverware, Ltd.\"\u2014\"La Compagnie d'Argenterie Chardo, Ltée\", incorporated by letters patent dated the 7th day of June 1946, under the name of \"Chardo, Ltd.\"\u2014 \"Chardo, Ltée\", and by supplementary letters patent dated the 6th day of December, 1948, changing this latter name to the aforesaid name ''Chardo Silverware, Ltd\"\u2014\"La Compagnie d'Argenterie Chardo, Ltée\",.again changing its name into that of \"Chardo Industries Limited\" \u2014\"Les Industries Chardo, Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Gatineau Lumber & Builders Supply Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the fifteenth day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Gatineau Lumber & Builders Supply Ltd.\", ratifying its by-law No.1A, increasing its capital stock from $50,000 to $100,000 by the creation of 500 additional common shares of a par value of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Hinda Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of October, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Hinda Chenilles Incorporated\", incorporated by letters patent dated May 2, 1947, into that of \"Hinda Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, the 11th day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney.General.La Compagnie C.A.Cayouette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-sixth day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"La Compagnie C.A.Cayouette Limitée\", ratifying its by-law No.21, extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Ladies' Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Nachlas Zkeinim Inc.(Ladies' Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Home for the Aged Inc.) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, 2530 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 1949, Tome SI, N° 44 1949, changeant le nom de la corporation \"B.& S.Steinhouse & Nachlas Zkeinim Inc.\"\u2014\"B.& S.Steinhouse & Home for the Aged Inc.\", incorporée par lettres patentes en date du 20 mars 1939, en vertu de la troisième partie de ladite Loi, en celui de \"Ladies Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Nachlas Zkeinim Inc.\" (Ladies Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Home for the Aged Inc.).Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015 L.DÊSILETS.L.Dupont Limitée Avis est donné qu'en jrertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 1er octobre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Dupont et Perrault Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 mai 1948, en celui de L.Dupont Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 1er octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.L'Édifice Montmorency Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 octobre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Financial Building Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 janvier 1929, en celui de \"L'Edifice Montmorency Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 6 octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.Le Sanatorium St-Jean Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi (S.R.Q.1941, chapitre 276), des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 octobre 1949, changeant le nom de la corporation \"Sanatorium de Macamic\", constituée par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi et datées du 8 mai 1947, en celui de \"Le Sanatorium St-Jean\".Daté du bureau du Procureur général, le 17 octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.changing the name of the corporation \"II.& S.Steinhouse & Nachlas Zkeinim Inc.\"\u2014\"B.& S.Steinhouse & Home for the Aged Inc.\", incorporated as such under the provisions of Part III of the said Act by letters patent dated March 20, 1939, into that of \"Ladies' Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Nachlas Skeinirn Inc.\" (Ladies' Auxiliary of the B.& S.Steinhouse & Home for the Aged Inc.).Dated at the office of the Attorney General, the 29th day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney General.L.Dupont Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the first day of October, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Dupont et Perrault Limitée\" incorporated by letters patent dated May 12th, 1948, to that of \"L.Dupont Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, this first day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.L'Édifice Montmorency Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the sixth day of October, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Financial Building Limited\", incorporated by letters patent dated the 22nd of January, 1929, into that of \"L'Edifice Montmorency Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Le Sanatorium St-Jean Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the seventeenth day of October, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with the provisions of section 2, of the said Act, (R.S.Q., 1941, chapter 276), changing the name of the corporation \"Sanatorium de Macamic\", incorporated by letters patent issued under Part III of the said Act, and dated the 8th of May, 1947, into that of \"Le Sanatorium St-Jean\".Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Les Ateliers de St-Anselme Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 septembre 1949, à la compagnie \"Les Machineries de Chez Nous Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er mars 1949, ratifiant: 1°) son règlement N° 2 augmentant le nombre de ses direc- Les Ateliers de St-Anselme Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-sixth day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Machineries de Chez Nous Limitée\", incorporated by letters patent dated the- 1st of March, 1949, ratifying: 1.) its by-law No.2 increasing the number of its directors from three (3) QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 19A9, Vol.81 No.U 2531 teurs de trois (3) à neuf (9); 2°) son règlement N° 3 étendant ses pouvoirs; 3°) son règlement I\\0 4 changeant son nom en celui de \"Les Ateliers «le St-Anselme Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 20 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 2001â-o L.DÊSILETS.Montreal Floor & Wall Tile Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt septembre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Montreal Floor and Wall Tile Inc.\", incorporée par lettres patentes en date du 4 juin 1927, en celui de \"Montreal Floor & Wall Tile Co.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le vingt-septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 20015 L.DÊSILETS.Paramount Fabrics Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du trois octobre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Paramount Coated Fabrics Ltd.\", incorporée par lettres patentes en date du 22 janvier 194G, en celui de \"Paramount Fabrics Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le trois octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 20015 L.DÊSILETS.to nine (9); 2.) its by-law No.3 extending its powers; 3.) its by-law No.4 changing its name into that of \"Les Ateliers de St-Anselme Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Montreal Floor & Wall Tile Co.Ltd.Notice is hereby given that under the provisions of Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Montreal Floor and Wall Tile Inc.\", incorporated by letters patent dated June 4th, 1927, into that of \"Montreal Floor & Wall Tile Co.Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, the 20th of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney General.Paramount Fabrics Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of October, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Paramount Coated Fabrics Ltd.\", incorporated by letters patent dated January 22, 1946, into that of \"Paramount Fabrics Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this 3rd day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney General.Quincaillerie & Matériaux de Construction Montréal-Sud Ltée Montrcal-Sud Hardware & Building Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 septembre 1949, changeant le nom de la compagnie \"Quincaillerie & Matériaux de Construction St-Georges Ltée\"\u2014 \"St-Gcorges Hardware & Building Supplies Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 août 1949, en celui de \"Quincaillerie & Matériaux de Construction Montréal-Sud Ltée\"\u2014\"Montreal Sud Hardware & Building Supplies Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 19 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-0 L.DÊSILETS.Secrétariat des Syndicats Catholiques de Québec Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 3 octobre 1949, à la corporation \"Secrétariat des Syndicats Catholiques de Québec Inc.\", constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite Loi, ratifiant son Règlement Spécial \"A\" étendant Quincaillerie & Matériaux de Construction Montréal-Sud Ltée Montreal-Sud Hardware & Building Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the nineteenth day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Quincaillerie & Matériaux de Construction St-Georges Ltée\"\u2014\"St-Georges Hardware & Building Supplies Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 11th of August, 1949, into that of \"Quincaillerie & Matériaux de Construction Montréal-Sud Ltée\"\u2014\"Montreal-Sud Hardware & Building Supplies Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Secrétariat des Syndicats Catholiques de Québec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the tnird day of October, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the corporation \"Secrétariat des Syndicats Catholiques de Québec Inc.\", incorporated under Part III of the said Act, ratifying its Special By-law \"A\" extending its powers by increasing 2532 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 novembre 1919, Tome 81, N\" U ses pouvoirs en portant de $200,000.00 à $1,000,-000.00 le montant auquel seront limités les biens immobiliers que ladite corporation pourra désormais posséder.Daté du bureau du Procureur général, le 3 octobre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015-o L.DÊSILETS.from $200,000 to $1,000,0000 the amount to which the immovable property which the said corporation may henceforth hold is limited.Dated at the office of the Attorney General, this third day of October, 1949.L.DÊSILETS, 26015 Deputy Attorney General.Tyrol Sportswear Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du douze septembre1949, à la com pagnie \"Tyrol Sportswear Ltd.\", ratifiant son règlement N° 25 augmentant son capital autorisé de $20,000 à $60,000 par la création de 100 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune et de 300 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, lesquelles actions privilégiées seront sujettes aux droits, privilèges, limitations et restrictions mentionnés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015 L.DÊSILETS.Tyrol Sportswear Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Tyrol Sportswear Ltd.\", ratifying its by-law No.25 increasing its authorized capital from $20,000 to $60.000 by the creation of 100 additional common shares of $100 each and 300 additional preferred shares of $100 each, which preferred shares shall be subject to the rights, privileges, limitations and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 12th of September 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney General.United Store Equipment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt et un septembre 1949, à la compagnie \"United Store Equipment Inc.\", ratifiant son règlement N° 24 augmentant son capital de $40,000 à $100,000 par la création de 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et énumérant les privilèges attachés auxdites actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 26015 L.DÊSILETS.United Store Equipment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"United Store Equipment Inc.\", ratifying its by-law No.24 increasing its capital from $40,000 to $100,000 by the creation of 600 preferred shares of the par value of $100 each, and enumerating the privileges attaching to the said preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, the 21st day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney General.Val Hughes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du treize septembre 1949, à la com- {>agnie \"Montreal Blouse Ltd.\", incorporée par ettres patentes en date du 9 juillet 1941, ratifiant son règlement N° 23 : a) changeant son nom corporatif en celui de \"Val Hughes Inc.\"; b) augmentant son capital autorisé de $20,000 à $60,000 par la création de 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et énumérant les privilèges attachés auxdites actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le treize septembre 1949.L'Assistant-procureur général.26015 L.DÊSILETS.Val Hughes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Montreal Blouse Ltd.\", incorporated by letters patent dated July 9, 1941, ratifying its by-law No.23: a) changing its corporate name to that of \"Val Hughes Inc.\" ; b) increasing its authorized capital from $20,000 to $60,000 by the creation of 400 preferred shares of the par value of $100 each, and enumerating the privileges attaching to the said preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, the 13th day of September, 1949.L.DÊSILETS, 26015-o Deputy Attorney General.Volcano (Service) Limitée Volcano (Service) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 septembre 1949, changeant le nom de la compagnie 'Volcano Sales Limited\", Volcano (Service) Limitée Volcano (Service) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the thirtieth day of September, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Volcano Sales Limited\", incor- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 6th, 19A9, Vol.81, No.U 2533 con-tit née en corporation par lettres patentes en date dit 19 octobre 1945, en celui de \"Volcano (Service) [imitée\" \u2014 \"Volcano (Service) Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 30 septembre 1949.L'Assistant-procureur général, 2.101 ô-o L.DÊSILETS.porated by letters patent dated October 19,1945» to that of \"Volcano (Service) Limitée\" \u2014 \"Volcano (Service) Limited\".\u2022 Dated at tlie office of the Attorney General, this thirtieth day of September, 1949.L.DÊSILETS, 20015 Deputy Attorney General.Arrêtés en Conseil ARRfcTÊ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1200 Québec, le 27 octobre 1949.Présent : Ix?Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Co\\it en outre assujetti à tous autres règlements relatifs à ladite Réserve et qui pourront être mis en force après avis régulier «lans la GazAte officielle de Québec: 6° Que le personnel «les barrières, ainsi que les gardes-chasse et les gardiens soient autorisés à perquisitionner les voitures quand la chose semblera nécessaire, et à confisquer le poisson, le gibier ou les agrès de pêche ou de chasse de toute personne qui n'aura pas observé les présents règlements ou tous autres qui pourront être adoptés par la suite; 7° Que les chefs d'exploitation de bois, les contre-maîtres, les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs d'opérations forestières, les exploitants de mines, ainsi que leurs employés, na puissent pêcher ou faire pêcher «lans les limites «le cette Réserve sans avoir préalablement obtenu un permis; 8° Qu'il soit strictement défendu: a) de pénétrer dans les Réserve sans s'enregistrer à l'une des barrières et sans y déclarer l'endroit et la durée de son séjour; b) de stationner, camper ou s'établir ailleurs qu'aux endroits établis à cette fin; c) de poser des affiches quclcoiupies, dans aucun endroit «le la Réserve, sans une permission écrite du département ; d) de chasser dans les limites de la Réserve, ou d'y avoir des armes à feu ou des pièges en sa possession ; e) de pécher dans la Réserve sans être muni du permis de pêche général de résident ou de non-résident, et sans avoir obtenu le permis spécial d'un dollar ($1.) par jour de pêche; 9° Que les lois générales relatives à la pêche et à la protection contre le feu s'appliquent à la Réserve, indépendamment «les présents règlements; 10° Que les gardes-chasse, garde-feu et gar-de-péche aient le devoir d'ejciger la production des* permis de toute personne séjournant ou de passage dans ladite Réserve ; 11° Que toute personne de passage ou séjournant dans la Réserve soit tenue responsable de tout dommage qu'elle aura pu causer par le feu ou autrement; 12° Que personne n'ait le droit de s'établir sans titre dans la Réserve, pour quelque raison que ce soit, et les gardes-chasse, garde-pêche et garde-feu soient autorisés à détruire les campements érigés sans permis; Lacroix, with the exception of the surveyed part of range one (1), that part of the township Courcelette not already included in the (bis-pesian Park, with the exception of the surveyed part of ranges A and B as well as the surveyed terrain stituate south of the \"Côté\" stream.The parts of the townships Lapotardière, Bois-buisson, including Lake Claude, and Larivièiv, not already included in the Gaspcsian Park,' namely a superficial area of two hundred and ninety-seven (297) square miles, be constituted a hunting and fishing reserve, under the naine of the Hunting and Fishing Reserve of Schick Schocks; 2.That it be most especially prohibited to hunt therein, kill or take any game, animal or wild birds whatsoever, from now intil the first of November 1954; 3.That carrying fire-arms be prohibited throught the whole territory; 4.That no one be allowed to fish in the waters of the said Reserve without a special permit issued by the Minister of Game and Fisheries or by one of the officers authorized by the Department; 5.That any angler be moreover subject to all other regulations respecting the said He-serve and winch may be enforced after due notice in the Quebec Official Gazette; 0.That the staff at the gates, as well as the game-wardens and rangers he authorized to search vehicles when deemed necessary, and to confiscate the fish, game, fishing tackle or hunting gear of any one who has not observed the present regulations or any others which may be adopted hereafter; 7.That the heads of lumbering operations, the foremen, contractors or sub-contractors of lumbering operations, operators of mines and also their employees, arc not allowed to fish or have fishing done within the limits of the said Reserve without having previously obtained a permit; 8.That it be strictly prohibited: a) to enter the Reserve without registering at one of the gates and without declaring where and how long he will stay; b) parking, camping or settling elsewhere than at the places established for such purpose; c) affixing signs whatsoever, anywhere within the Reserve, without a written permission from the Department; d) hunting within the limits of the Reserve, or having firearms or traps in his possession ; e) fishing within the Reserve without a general fishing permit or a resident or non-resident permit, and without having obtained the special permit of one dollar ($1) per each fishing day; 9.That the general laws respecting Fishing and Fire-Protection apply to the Reserve, irrespective of the present regulations; 10.That the Game-Wardens, Fire Rangers and Fishery-Overseers be duty bound to exact the showing of permits from everyone sojourning in or travelling through the said Reserve; 11.That every person travelling through or sojourning in the Reserve be held responsible for any damge caused by him through fire or otherwise; 12.That no person shall have the right to settle without title within the Reserve, for any reason whatsoever, and the grm?wardens, fishery -overseers and fire rangers be authorized to destroy any camping sites erected without permit; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 6th, 19A9, Vol.81, No.U 2535 13° Que personne ne soit autorisé à servir comme guide dans la Réserve sans avoir préalablement été assermenté comme garde-pêche, Ijarde-chasse ou garde-feu ; 14° Que toute contravention aux présents règlements soit punissable sommairement d'une amende, en sus des frais, de pas moins de cinq dollars ($5.) et de pas plus de cinquante dollars ($50.), ou à défaut «le paiement, d'un emprisonnement de quinze (15) jours au moins et de trois Cl) mois au plus, tel que prévu a l'article 76 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec, 1941.?A.MORISSET, 26019-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1197 Québec, le 27 octobre 1949 Présent] Le Lieutenant-Gouvcrneur-en-Conseil Section \"D\" Concernait une correction du décret relatif aux épiciers-bouchers dans la cité de Jolictte.Attendu que le Syndicat catholique et national des employés épiciers et bouchers de Joliette Inc., partie contractante de deuxième part à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 1336 du 18 avril 1946 et amendements, relatif aux épiciers-bouchers dans la cité de Joliette, a été autorisé par l'honorable secrétaire o>e la province, en date du 9 janvier 1948, à changer son nom en celui de \"Syndicat catholique et national des employés du commerce de Joliette\".' Attendu Qu'un avis à ce sujet, a dûment été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 17 janvier 1948; Il est ordonné, en conséquence sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 1336 soit corrigé comme suit: Le nom de la partie contractante de deuxième part est radié et remplacé par le suivant: \"Le Syndicat catholique et national des employés du commerce de Joliette\".(Document \"D\" annexé à l'arrête) A.MORISSET, 21018-o \u2022 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1197 Québec, le 27 octobre 1949.Présent: Le Lieutenant-Gouvemeur-en-Conseil Section \"B\" Concernant une modification du décret relatif à 1 industrie de la construction et de la réparation mécanique dans la région de Québec.13.That no person be authorized to act as guide in the Reserve without having previously been sworn in as fishery-overseer, game warden or fire ranger; 14.Any infringement of the present regulations shall be summarily punishable by a fine, over and above costs, of not less than five dollars ($5) and not more than fifty dollars ($50), or, failing payment, to imprisonment of not less than fifteen (15) days and not more than three (3) months, as provided for by section 76 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.A.MORISSET, 26019 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1197 Quelle, October 27, 1949.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"D\" Concerning a correction of the decree relating to the grocers and butchers in the city of Joliette.Whereas \"Le Syndicat catholique et national des employés épiciers et bouchers de Joliette Inc.\", contracting party of the second part to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 1336 of April 18, 1946, and amendments, relating to the grocers and butchers in the City of Joliette, has been authorized by the Honourable Secretary of the Province, on January 9, 1948, to change its name into that of \"Syndicat catholique et national des Employés du Commerce de Joliette.\" Whereas a notice to that effect has been duly published in the Quebec Official Gazette, issue of January 17, 1948; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1336, be amend-ded as follows: The name of the contracting party of the second part is deleted and» replaced by the following: \"Le Syndicat Catholique et national des employés du commerce de Joliette\".(Document \"D\" annexed to the Order) A.MORISSET, 26018-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1197 Quebec, October 27, 1949.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"B\" Concerning an amendment of the decree relating to the mechanical engineering industry in the district of Quebec.Attendu que, conformément aux dispositions Whereas, pursuant to the provisions of the de la Loi de la convention collective (Statuts Collective Agreement Act (Revised Statutes 8886 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, f, novembre 1919, Tome 81, A'° u refondus de QucIh'c 1941, chapitre l(i.\"{ et amendements), une requête a été pré'sentée au Mi~ nistre du Travail par le Comité paritaire de l'Industrie de la ('oustruction et de la Réparation mécanique de la région de Québec, à l'effet de modifier le décret numéro 973 du 80 juin 1048 et amendements, relatif à l'industrie de la Construction «'t de la réparation mécanique dans la région de Québec; Attendu «pie ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 17 septembre 1949; Attendu ur'aueunc objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est okdonnk.en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 973 soit modifié comme suit: Le paragraphe V de l'article VII est radié et remplacé par le suivant: \"c) Au terme «le son apprentissage tout apprenti a «lroit à une augmentation «le 10% sur le salaire «le l'apprenti de 4ème année et à une deuxième augmentation de 10% après une période additionnelle de pas moins de six mois.Au terme de ce deuxième 10%, l'apprenti doit subir un examen (levant le bureau des examinateurs.Selon le résultat de cet examen, l'apprenti est classifié compagnon ou demeure apprenti de lènie année, deuxième 10%.Cet examen peut être répété à toutes les périodes additionnelles d'une année d'apprentissage.\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 20018-o Greffier du ('onseil Exéeut if.ARRÊTE EX CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1197 Québec, le 27 octobre 1949.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant des mollifications au décret relatif à l'industrie de la Robe dans la province de Québec.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi «le la Convention collective (Statuts refondus de Québec 1941.chapitre 1G3 et amendements), la Commission conjointe «le l'industrie de la Robe «le la province de Québec a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet «le modifier le décret numéro 3619 du 24 septembre 1940, relatif à l'industrie «le la rol>e dans la province de Québec, et ses amendements ; Attendu qui ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition «lu 3 septembre 1949; Attendu que les objections formulées contre l'approbation des modifications proposées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est okdonnk, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 3519, soit modifié comme suit: 1° L'alinéa \"6\" du paragraphe \"1\" de l'article X-A intitulé \"Congés annuels payés \" est remplacé par le suivant: of Quebec 1941.chapter 168 and amendments), a request has been submitted to the Minister of Lai KHir by the ( omite paritaire de l'Industrie de la Construction et de lu Réparation niéea-nique de lu région de Québec for the purpose (1f amending the decree number 973 of June 30, M.)IS, ami amendments, relating to the in«-ehani-eal engineering industry in the district of Que.bee; Wiikueas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of September 17.1949; WhIBMAS no objection has been made against the approval of the draftghl amendment; It is ordained, ther«'fon\\ upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 973, be amended as follows: Subsection \"c\" of section VII is deleted and the following substituted therefor: \"c) At the expiration of his apprenticeship period every apprentice is entitled to an increase cration 345-2 is replaced by the following: Laying sole, middle-sole or platform.\" 6.Section 14 is amended as follows: Operation 403-6 becomes operation 403-5; Operation 404-3 is replaced by the following: \"404-3.Assembling sole, wedge heel or platform before the fixing of the sole on the shoe.This operation includes: Pressing (or pounding) the sole, the shank heel, the platform before the fixing of the sole.Pressing (or pounding) the entire sole, including the sole, the platform, the shank heel, after the fixing of the sole on the shoe.Insert, platform only in upper, Korker or California process.\" The following operation 404-5A is added: \"404-5A.\"Pressing (or pounding) sole, wedge heel, platform, before the fixing of the sole.\" Operation 405-1 is replaced by the following: \"405-1.Sewing, cementing, pegging, standard screwing, loose nailing sole on shoe, fixing sole, California process; fixing complete sole including platform, sole and wedge or spring heel.This operation includes also: wetting sole, cutting threads, filling bobbin, cementing or laying solvent.\" Operation 415-6-A becomes operation 415-5-A; Operation 421-6A becomes operation 421-5-A.7.Section 15 is amended as follows: Operation 500-6A becomes operation 500-5A; Operation 503-6A becomes operation 503-5A; In operation 510-5A, the following words are added after the word \"screw\": \"final setting of heel already in place with nails driven through the inside of the shoe.Note: Laying or adjusting of wedge heel on shoe belongs to operation 422-1.\" The following operation is added: \"511-4A.Removing paper cover on upper when this operation is not made by the employee committed to the treeing.\" Operation 513-6 becomes operation 513-5; Operation 519-4 is replaced by the following: \"519-4.Examining, cleaning or repairing.This operation includes also: spraying or dressing\"; Operation 520-5 becomes operation 520-5A.8.Section 17 is amended as follows: In operation 600-A, the following words are added after the words \"sewing top facing\": \" list cutting on machine, cementing and folding the stripping or piping.Note: The employee who does folding and cements for so doing belongs to class A.\" 9.Section 24 is amended as follows: 1) Subsection \"b\" is replaced by the following: \"6) The remuneration of this vacation week shall be 4% of the wages received by the era- Sloyee during the period from January 1st to une 30 prior to the vacation.\" 2540 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 6 novembre 19A9, Tome 81, N° U 2.I* «leuxiènie alint-a du paragraphe \"A\" est 2) The second paragraph of subsection \"h\" remplacé par le suivant: is replaced by the following: \"La rémunération de cette 2ème semaine de \"The remuneration for that second vacation .«acances doit être de 4% du sulaire reçu par le week shall be 4% of the wages received bv the salarié pendant la période du 1er juillet au 31 employee during the period from July 1st to décembre précédent les vacances.\" December 31st prior to the vacation.\" 10° Le paragraphe \"i\" suivant est ajouté à 10.The following subsection \"i\" is added to l'article 24: .section 24: \"i) L'employeur peut calculer sa paie «le va- \"i) The employer may compute the vacation cances comme suit: vacances «le juillet, 4% du pay as follows: July vacation, 4% of the wages salaire reçu par le salarié dans la période «lu 1er receive*! by the employee during the period from Janvier au 31 mai précédant Id vacances, phis January 1st to May 31st prior to the vacation, 1/5 «le ce montant pour couvrir le mois «le juin; plus 1/5 of such amount to cover the month of vacances «les fêtes, 4% du salaire reçu par le sa- June; Winter vacation, 4% of the wages received larié dans la période du 1er juillet au 30 novem- by the employee during the period from Julv 1st bre précédant les vacances, plus 1/5 «le ce mon- to November 30 prior to the vacation, plus 1/5 of tant pour couvrir le mois «le décembre.Ce- the total amount to cover the month of Decern, pendant, le comité paritaire a la droit de véri- ber.However, the Parity Committee has the fier la méthode «le calcul de cette paie de vacan- right to check the method of computing this va-ces et peut l'approuver ou non, schm le cas.\" cation pay and may approve it or not, as the ease may be.\" 11° L'article 34 est.remplacé par le suivant: 11.Section 34 is replaced by the following: \"Art.34.Ix's salaires, qu'ils soient calculés \"Section 34.Wages, whether calculated on suivant le taux horaire, suivant une base hclxlo- an hourly, weekly, piece-work or other basis, madaire, suivant un système à la pièce, ou tout shall be paid entirely in currency, legal in this autre mode, doivent être payés entièrement en Province, and, regularly, once a week or once a deniers ayant cours légal «lans cette province «-t forthnight.\" régulièrement une fois la semaine ou une fois la quinzaine.'' 12° L'article 34A suivant est ajouté: 12.* The following section 34A is a«l«led: \"Art.34A.Le comité paritaire prépare les \"Section 34A.The Parity Committee shall réclamations sur une période «l'un mois, c'est-à- extend the daims over a period of one month, i.e.«lire sur la pérhxle couverte par le rapport men- over the period covered by the monthly report sud adressé au comité paritaire.Toutefois les sent to the Parity Committee.However, claims réclamations sont établies, semaine par semaine, shall cover week by week periods in the following dans les cas suivants: cases: a) lorsque le manufacturier adresse au co- a) when the manufacturer forwards weekly mité «les rapports bebf the National Bivwcrics Limited\" tenue à la Hrass«'rie Dawes Black Horse, 740 rue St-Maurice, en la cité «le Montréul.Québec, mardi le 31 mai 1049, le nom du club sustlit a été, par une résolution «lûment adoptée à cette fin.changé en celui de \"Quurter Century Club of National Breweries Limited\", et ce con-formément aux dispositions «le l'article 4 «le la Loi des clubs «le récréation, S.R.Q.1941, chapitre 304.Donné au bureau «lu Secrétaire «le la Province, le 3 novembre 1949.Le Sous-secrétaire «le la Province, 20047 JEAN BRUCHÉSI.Unity Boys' Club Copie certifiée du règlement N A Règlement \".4\" \"Qu'il soit «lécr«'\"té et il est.par les présentes, décrété comme un règlement «le Unilv Bov's Club: 1.\u2014 I>e nombre «les membres du bureau de direction «lu club sera et il est, par les présentes.augmenté de cinq (5) à once (11).2.\u2014 l/cs règlement! du club seront et ils sont, par les présentes, modifiée conformément au présent règlement\".Copie conforme certifiée «l'un règlement adopté \u2022 à l'unanimité à une assemblée «les membres de Unity Boys' Club tenue en la cité de Montréal, le 7 septembre 1949.I/c Secrétaire, 26048 W.-G.MOXLEV.La Société des Hommes d'Affaires de l'Est de Montreal Extrait du Règlement X° 28.tel qu'amendé, «le la société précitée, concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs à vingt-cinq: \"Le nombre «les directeurs au Conseil sera de 25.\" Copie certifiée conforme.Le Président, LUCIEN ROY.Le Secrétaire, 26049-o CLÉMENT LIMOGES.St-Maurice Flying Services Limited Extrait des minutes d'une assemblée «les directeurs de la compagnie St-Maurice Flying Services Limited «lûment tenue le 1er août 1949 : Règlement numéro III \"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de «lirection de quatre directeurs et, en conséquence, le nombre des directeurs est, par les présentes, augmenté «le trois à quatre.\" Le Président, (Signé) W.STANSFIELD.Le Secrétaire, (Signé) M.G.PRESTON» Extrait conforme certifié.« Par ordre du bureau de direction.(Sceau) L'Assistant-secrétaire, 26051 ROGER DESHAIES.Notice is hereby given that, at the Annual General Meeting of Members of \"Quarter (Vii-tury (,'lub of the National Breweries Limited\", held at the Dawes Black Horse Brewery, 710 St.Maurice St.in the City bonds or debentures to lie redeemed serially from August 1, 1950 to August 1, 1900; (County of U Assomption) School Commission of the Town of Lei Lau-rentfdes: Issue $20,000.00, dated July 1, 1!H7, 0%, bonds or debentures to be redeemed serially on July 1, 1950 ami 1951; (County of ImvuI) School Commission of the Town of Ste.Rose: Issue $25,000.00, dated July 1, 1935, bonds or debentures to l>e redeemed serially on January 1 and July 1, 1950 to 1900; (County of Papineau) School Commission of Notre Dame des Neiges de Masson: Issue $45,000.00, dated August 1, 1939, 4%, bonds or debentures to be redeemed serially from August 1, 1950 to August 1, 1954; (County of Port neuf) School Commission of St.Remi du Lac aux Sables: Issue $10,000.00, dated April 1, 1929, 5%, bonds or debentures to be redeemed on July 1, 1950; (County of Témiscamingue) School Commission of St.Placide de Beam: Issue $10,000.00, dated July 1, 1930, 6%.bonds or debentures to be redeemed on July 1, 1950.Dated at Quebec, this 2nd day of November 1949.The Quebec Municipal Commission, per CHARLES A.COUILLARD, 26053-o Secretary.» 1 1 ¦ - Département de l'Instruction publique -\u2014-m- \"Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur en Conseil, par arrêté en conseil N° 1205 en date du 27 octobre 1949, d'amender l'arrêté en conseil N° 285 en date du 4 mars mars 1948, concernant l'érection de la commission scolaire centrale Macdonald suivant une résolution du comité protestant du conseil de l'Instruction publique adoptée à une assemblée tenue le 30 septembre 1949, pour inclure les syndics d'écoles de la commission scolaire protestante, de l'Ile Perrot, comté de Vaudreuil, dans ladite commission scolaire centrale Macdonald, conformément aux dispositions de la Loi 8 Geo.VI, chapitre 15, article 7.\" 2 novembre 1949.Pour le Surintendant, 26037 W.P.PERCIVAL.Department of Education \"His Honour, the Lieutenant-Govcrnor-in-Council has been pleased, bv Order-in-Council No.1205, dated October 27th, 1949, to amend Order-in-Council No.285, dated March 4th.1948, concerning the erection of the Macdonald Central School Board in accordance with a resolution of the Protestant Committee of the Council of Education adopted at a meeting held on September 30th, 1949, to include the Protestant Board of School Trustees of He Perrot, county of Vaudreuil, in the said Macdonald Central School Board, in accordance with the provisions of the Article 8 Ceo.VI, Chapter 15, Section 7.\" November 2,1949.W.P.PERCIVAL, 26037-o For the Superintendent. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 1949, Vol.81, No.U 2549 X° 398-49.Québec, le 21 octobre 1949.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Inverness, dans le comté de Mégan-tic.les terrains suivants du canton d'Inverness, savoir: 100 acres nord-est du lot no 313 appartenant à Robert Beaudoin, le lot 311 et le lot 310, |ee 75 acres nord-oucat du lot 309, appartenant à Raymond Carrier, tous «lu rang V; dans le rang VI, le lot 421 au lot 304 inclusivement, y compris tous les emplacements du village d'Inverness.tons «lu rang VI.Dans le rang VII.le lot 495 inclusivement au lot 459, 457, et la moitié sud-OUSll du lot 458 appartenant à Vincent O'Malley, v compris tous les emplacements du village d'In-vemess et d'ériger tout ce territoire en municipalité molaire distincte, pour les catholiques seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire Catholique du Village d'Inverness\", comté de Mé-gantic.Le Surintendant de l'Instruction publique, 25992-43-2-0 O.J.DESAULNIERS.No.398-49.Quebec, October 21, 1949.\u2022Application is made to detach from the school municipality of Inverness, in the county of Me-gantic, the following lots of land of the township of Inverness, to wit: the 100 northeast acres of lot 313 belonging to Robert Beaudoin, lot 311 and lot 310, the northwest 75 acres of lot 309, belonging to Raymond Carrier, all in range V; in range VI, lot 421 to lot 304 inclusively, including all the emplacements of the village of Inverness, all of range VI.In range VII, lot 495 inclusively to lot 459, 457, and the southwest half of lot 458 belonging to Vincent O'Malley, including all the emplacements of the Village of Inverness and to erect all this territory into a separate school municipality, for Catholics only, under the name of \"The Catholic School Municipality of the Village of Inverness\", county of Megantic.0.J DESAULNIERS, 25992-43-2 Superintendant of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de L'Ile Bi/ard (Maintenant municipalité de St-Raphael de L'Ilc-Bizard) division d'enregistrement de Montréal.le vous donne avis que les lots 25-1 à 25-89 sunt annulés en vertu de l'article 2174A du ('nie civil.Québec, le 24 octobre 1949.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 26017-O A VILA BÊDARD.Département du Trésor Avis de rachat par anticipation Province de Québec 11,050,000 d'obligations 3%% en date du 1er février 1941, échéant le 1er février 1951 Avis est donné par les présentes que l'émission de $1,050,000 d'obligations Z%% en date du 1er février 1941 de la Province de Québec, effectuée sous l'autorité de la Loi 1 Edouard VIII (2è session), chapitre 2, et remboursable par anticipation selon la teneur des obligations, est, par les présentes, appelée pour rachat le 1er février 1950 au montant nominal du capital plus l'intérêt couru jusqu'à la date précitée du rachat.Les obligations comportant tous les coupons dont la date d'échéance est postérieure au 1er février 1950, peuvent être remises contre paiement en monnaie légale du Canada, aux banques et aux lieux de paiement indiqués dans le texte des obligations.Les obligations enregistrées devront être accompagnées de tous les documents nécessaires au transfert.L'intérêt sur toutes ces obligations cessera de courir le 1er février 1950 et postérieurement l cette date les détenteurs de ces obligations Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the Parish of LTle Bizard (now Municipality of St-Raphael of LTle Bizard) Registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 25-1 to 25-89 are cancelled in virtu of Article 2174A of the civil Code.Quebec, October the 24th, 1949.Department of Lands and Forest, Cadastral Branch, A VILA BÊDARD, Deputy Minister.Treasury Department Notice of Redemption ¦i.Province of Quebec $1,050,000 3%% Debentures dated February 1st, 1941 maturing February 1st, 1951 Notice is hereby given that the $1,050,000 $H% Debentures dated February 1st, 1941 of the Province of Quebec, issued under the authority of the Act 1 Edward VIII (2nd Session), Chapter 2, and subject to prior redemption according to the terms of the Del>entures, are hereby called for redemption on the first day of February, 1950 at their principal amount plus interest accrued to the said redemption date.Debentures, with all coupons maturing after February 1st, 1950 attached, may be surrrend-ered against payment in lawful money of Canada, at the banks and the places of payment stipulated in the Debentures.Registered Debentures should be accompanied by all instruments requisite for transfer.Interest on all of such Debentures shall cease to accrue on the first day of February, 1950 and thereafter the holders of such Debentures shall 3560 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 1919, Tome 81, N° U n'auront le droit de recevoir que le paiement du capital ct\",de l'intérêt couru à la date précitée du rachat.Phovince de Québec, ONKSIME GAGNON, Trésorier de la Province.le 5 novembre 1949.2G016-o have no rights except to receive payment of principal and accrued interest to the said re-demption date.Province of Quebec, ONESIME GAGNON, Provincial Treasurer.November 5th, 1949.26010 Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BAREAU DE QUÊEBEC \u2014 BAR OF QUEBEC Candidat pour l'admission A l'étude du droit Candidates for thr admission to thr study of law Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tRésidence Residence\tCollèges Colleges \t\t21\t\tEcole St-François-Xavier (Levis) et Collège de Levis.\t\t\t\t Québec, le 24 octobre, 1949 \u2014 Quebec, October 24th, 1949.26003-43-2-o Le Secrétaire du Barreau de Québec, ROGER THIBAUDEAU, Secretary of the Bar of Quobec.Lettres patentes Canada.Province de Quél>ec.[L.S.] EUG.FISET Letters Patent Canada, Province of Quebec.IL.S.] EUG.FISET GEORGE VI, par la grâce de Dieu, Roi de Gran- GEORGE VI, by the Grace of God, of f.reut de-Bretagne, d'Irlande et des territoires bri- Britain.Ireland and the British Dominions tanniques au delà des mers.Défenseur de la beyond the Seas, King, Defender of the Faith.Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerne- To all to whom these presents shall come or ront ou qui les verront, salut.whom the same may concern, Greetixu.LETTRES PATENTES Attendu que la Loi des cités et villes décrète que le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut ériger, par lettres patentes, après l'accomplissement des formalités prescrites, le territoire d'une municipalité de village en municipalité de ville, s'il contient une population d'au moins deux mille âmes: Attendu que le conseil de la municipalité du village de Charlesbôurg, dans le comté de Québec, conformément à une résolution régulièrement adoptée à sa session du 20 décembre 1948, Nous a présenté une requête demandant que le territoire de ladite municipalité du village de Charlesbôurg,' tel que décrit dans la description officielle du département des terres et forêts en date du 7 février 1949, soit érigé en municipalité de ville comprenant un seul quartier représenté par six échevins, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la loi des cités et villes (S.R.Q.1941, ch.233; Attendu que la population de la municipalité du village de Charlesbôurg établie par le recensement fait conformément à la loi est de quatre mille sept cent soixante-treize âmes; LETTERS PATENT Whereas the Cities and Towns Act enacts that the Lieutenant-Governor in Council may erect, by letters patent, after fulfilment of the formalities prescribed, the territory of a village municipality into a town municipality, if it contains a population of at least two thousand souls; Whereas the council of the municipality of the village of Charlesbôurg, in the county of Quebec, pursuant to a resolution duly adopted at its meeting of the 20th of Deceml>er, 1948 has presented to Us a petition requesting that the territory of the said municipality of the village of Charlesbôurg, as described in the official description of the Department of Lauds and Forests dated the 7th of February, 1949, be erected into a town municipality comprising one single ward represented by six aldermen, pursuant to the provisions of paragraph 3 of section 15 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1941, chap.233); Whereas the population of the municipality of the Village of Charlesbôurg established by the census taken in conformity with the Law is four thousand seven hundred and seventy-three souls; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 19 Ail, Vol.81, No.AA 2551 AtTINBTJ quo toutes les formalités proscrites par la loi ont été remplies; A CM causes, de l'avis et e made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major General, the Honourable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt., C.M.G.D.S.O.M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this Twentieth day of October, in the year of Our Lord, nineteen hundred and forty-nine and the thirteenth year of Our Reign.By command, JEAN BRUCHÉSI, 26055 Under Secretary of the Province.Head Offices Notice is hereby given that \"J.Beaudoin Ltée\" incorporated by letters patent under the Quebec Companies Act, on the 13th of September 1949, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 2100 Frontenac Street, in the said city of Montreal. 2552 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 novembre 1919, Tome 81, M° U A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné ù Montréal, ce 26e jour de septembre 1949.(Sceau) La Présidente, 26031-o Jeannette Sauvageau Beaulieu Avis de l'adpesse du hikgesocial de \"Cosmos (Qu ;bec) Ltd.\" Avis est donné par les présentes cpie \"Cosmos (Quebec) Ltd.\", constitué en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le premier septembre 1919, a établi son siège social à 1434 rue Ste-Catborine ouest, Montréal, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 26e jour d'octobre 1949.Le Président, 26023 Coxstaxtixe P.Couropoulos.AVIS Hatchcraft Ltd.Avis est donné que le bureau chef de \"Hatcb-craft Ltd.\" est situé à 615 rue St-Vallier.Québec, P.Q., et non à 54 rue St-Vallier tel que mentionne par erreur dms l'avis publié dans le numéro 41 du tome 81 de la Gaz.tte officielle de Québec.Québec, le 26 octobre 1949.Le Secrétaire, 26024-o JACQUES de BILLY.Avis de situation du siège social de \"Standard Duplicators Limited\" Avis est, par les présentes, donné quo la compagnie \"Standard Duplicators Limited\", une compagnie incorporée par lettres patentes en date du 11 décembre 1948, conformément à la première partie de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social i\\ Montréal, a établi son bureau au numéro 179 ouest, rue Craig, Montréal.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Et j'ai signé à Montréal, le 25 novembre 1949.Le Secrétaire, 26025 E.McELROY.Ventes \u2014 Loi de faillite Sous la Loi de Faillite VENTE A L'ENCHERE PUBLIQUE Dans l'affaire de François Champagne, horticulteur, Saint-Georges-Est, Co.Beauce, P.Q.Avis est par les présentes donné que LUNDI, le 5 DECEMBRE 1949, à DIX HEURES TRENTE A.M.(heure solaire) seront vendus à la porte From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 26th day of September 1949.[Seal] Jeannette Sauvageau Beaulieu, 2603 l-o President.Notice ok Address of Head Office of \"Cosmos (Quebec) Ltd.\" Notice is hereby given that \"Cosmos (Quel), e) Ltd.\" incorporated by Letters Patent under Part I of the Quebec Companies' Act on Sep.tomber 1st, 1949, has established its Head Office at 1434 St.Catherine Street West, Mont-real, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall l>e considered by the Company as being the Head Office of the Company.Dated at Montreal, this 20th day of October.1949.CoNSlantine P.couropoulos, 26023-o President.NOTICE Hatchcraft Ltd.Notice is given that the head office of \"Hatcli-craft Ltd.\" is situated at 015 St-Vallier Street, Quebec, P.Q.and not at 54 St-Vallier Street, as mentioned, by mistake, in the notice published in number 41 of volume 81 of the Quebec Official Gazette.Quebec, October 20.1949.JACQUES de BILLY.26024 Secretary.Notice of the Situation of the Head Office of \"Standard Duplicators Limited\" Notice is hereby given that \"Standard Duplicators Limited,\" company incorporated by letters patent dated December 11th, 1948, according to Part I of the Quebec Companies' Act, and having its head office in MontroaJ.has established its office at Number 179 Craig Street West, Montreal; From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the said Company as being the head office of the Company.And I have signed at Montreal, this 25th day of October 1949.E.McELROY, 2G025-o Secretary.Sales \u2014 Bankruptcy Act Under the Bankruptcy Act PUBLIC AUCTION SALE In the matter of Francois Champagne, horticulturist, Saint-Georges East, county of Beauce, P.Q.Notice is hereby given that on MONDAY, the FIFTH day of DECEMBER.1949, at TEN THIRTY o'clock A.M.(Standard Time), there QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 1919, Vol.81, No.U 2553 de l'église paroissiale de Saint-Georges, Co.Beau-ce, les actifs suivants: Lots nos 610-28 \u2014 25 lots à bûtir, subdivisions du lot no 610 de la paroisse de Saint-Georges-Est, Co.Beauce: Lots No 010-28 \u2014 1-2-3-7-8-9-10-12-15-10-19-20-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-33-35-30.avec bâtisses ci-dessus construites, circonstances et détHMidances.Conditions de vente: comptant.Les actifs ci-dessus peuvent être examinés sur les lieux, samedi le 3 décembre 1949, de 9 heures du matin à midi et de deux heures à 5 heures p.m.Le Syndic.LS.-ROBERT RUEL.Bureaux: 1ère Avenue, Saint-Georges, Beauce, P.Q.20026-44-2-o will be sold, at the parochial church door of Saint Georges, county of Beauce, the following assets: Lots Nos.610-28 \u2014 25 building lots, subdivisions of lot No.010, of the parish of Saint Georges East, county Beauce.: Lots No.010-28 : 1-2-3-7-8-9-10-12-15-16-19-20-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-33-35-30, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Conditions of sale: cash.The above immovables may be examined, on the premises, on Saturday the 3rd day of December, 1949, from 9 o'clock in the morning until Noon and from two o'clock to five P.M.LS.ROBERT RUEL, Trustee.Offices: 1st Avenue, Saint Georges, Beauce, P.Q.26026-44-2 Loi de Faillite AVIS DE VENTE Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure \"En faillite\", N° 235.Dans l'affaire de: Jules Edouard Daneau, St-François du Lac, cédant autorisé, et Claude Perras, syndic.Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant savoir: \"Une portion de terre située en le village de St-François du Lac, de la contenance de cent trente-huit pieds de largeur sur soixante-dix pieds de profondeur, le tout mesure anglaise, le tout plus ou moins, tenant d'un bout, au nord-ouest à la rue Ste-Anne, de l'autre bout au sud-est à Pierre Desmarais, d'un côté au nord-est «à Albert Lachapelle, et de l'autre côté, au sud-ouest à Gérard Chapdelaine, avec bâtisses dessus construites.Laquelle portion de terre est décrite aux plan et livre de renvoi officiels pour la paroisse de St-François du Lac, comme étant une partie du lot numéro deux cent cinquante-huit (Ptie.258).Sera vendue à la porte de l'église paroissiale de St-François du Lac, comté Yamaska, à ONZE heures de l'avant-midi, LUNDI le CINQ DECEMBRE 1949.Cette vente est faite en vertu d'un jugement rendu par le Régistraire du Greffe des Faillites à Montréal, le 25 octobre 1949 et suivant les prescriptions de l'article 45 de la Loi de Faillite et avec l'effet du décret.Montréal, ce 25 octobre 1949.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: Perras & Perras, Syndics-Licenciés, 4 est, rue Notre-Dame, Montréal.25998-43-2-o Loi de Faillite AVIS DE VENTE Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, \"En faillite\", N° 213.Dans l'affaire de: Joseph Ovila Gourre et Pierre La-bossière, contracteurs et ayant fait affaires ensemble sous la raison sociale de \"Royal Construction Co.\", cédants autorisés, et Claude Perras syndic, Avis public est par les présentes donné que les emplacements désignés comme suit, savoir: Bankruptcy Act NOTICE OF SALE Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court (Sitting in Bankruptcy), No.235.In the matter of: Juies Edouard Daneau, St-François du Lac, authorized assignor; and Claude Perras, trustee.Public notice is hereby given that the following immovable, to wit: A portion of land situate in the village of St-François du Lac, measuring one hundred and thirty-eight feet in width by seventy feet in depth, the whole English measure and more or less, bounded at one end, to the northwest by Ste-Anne street, at the other end to the southeast, by Pierre Desmarais, on one side to the northeast by Albert.Lachapelle, and on the other side, to the southwest, by Gérard Chapdelaine\u2014with buildings thereon erected.The said portion of land being described on the official plan and in the book of reference for the parish of St-François du Lac, as being a part of lot number two hundred and fifty-eight (Pt.258).To be sold at the church door of the parish of St-François du Lac, county of Yamaska, at ELEVEN o'clock in the forenoon, on MONDAY the FIFTH day of DECEMBER, 1949.The said sale to be made in virtue of a judgment rendered by the Registrar of the Bankruptcy Office at Montreal, on the 25th of October, 1949, and pursuant to the provisions of Article 45 of the Bankruptcy Act and with the effect of a Sheriff's sale.Montreal, October 25, 1949.CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of: Perras & Perras, Licensed Trustees, 4 Notre-Dame Street East, Montreal.25998-43-2 The Bankruptcy Act NOTICE OF SALE Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court \"Sitting in Bankruptcy\", No.213.In the matter of : Joseph Ovila Gourre, and Pierre Labossière, contractors, and having carried on business together under the firm name of \"Royal Construction Co.\" Authorized Assignors; and Claude Perras, Trustee.Public notice is hereby given that the emplacements designated as follows, to wit ; 2554 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 novembre 19A9, Tome 81, N° U.\"Trois lots de terre ayant front sur la lOième Avenue dans le quartier Roscinont, dans la Cité de Montréal, portant les numéros quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, sur le plan et subdivision du lot originaire désigné par le lot numéro cent soixantc-dix-ncuf (179) aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé Côte Visitation (Nos.179-47, 179-4S, 179-49) avec bâtisse en voie de construction.\" Seront vendus suivant un jugement de lu Cour Supérieure pour le district de Montréal, \"en matière de faillite\" rendu le 25 octobre 1949 aux enchères publiques suivant les formalités de l'article 45 de la Loi de faillite, de manière à donner à cette vente l'effet du décret, au bureau du shérif du district de Montréal, au Palais de Justice en la cité de Montréal, VENDREDI le DEUXIEME jour de DÉCEMBRE 1949, à ONZE heures de l'uvant-midi.Conditions de paiement: COMPTANT.Pour informations et cahier des charges s'adresser au soussigné.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: Perras & Perras, Syndics-Licenciés, 4 est, me Notre-Dame, Montréal.25999-43-2-o \"Three emplacements fronting on Kith Avenue, in Rosemount ward, in the city of Montreal, bearing numbers, forty-seven, forty-eight, forty-nine, on the plan and subdivision of the original lot designated under lot numl>er one hundred ami seventy-nine (179), of the official plan and book of reference for the incorporated village of Côte Visitation (Nos.179-47, 179-48, 179-49) with a building Under construction.Will be sold in virtue of a judgment of the Superior Court of the district of Montreal, \"sitting in Bankruptcy\", rendered on October 25, 1949, by public auction, pursuant to the formalities of section 45 of the Bankruptcy Act, so as to give to the said sale the effect of a Sheriff's Sale, at the Sheriff's Office of the district of Montreal, at the Court House, in the rity of Montreal, on FRIDAY, the SECOND day of DECEMBER, 1949, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Conditions of Payment : CASH.For information and list of charges, apply to the undersigned.CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of : Perras & perras, Licensed Trustees, 4 Notre-Dame Street East, Montreal.25999-43-2 Vente par limitations Sale by Licitations AVIS DE LICITATION Canada, Province de Québec, District de Québec, Cour Supérieure Avis est donné en vertu du jugement de la Cour Supérieure siégeant à Québec, dans le district de Québec, le 22 octobre 1949.dans une cause dans laquelle Mademoiselle Elise Lamotbe est demanderesse, ordonnant la licitation de certain immeuble désigné comme suit, savoir: \"Un immeuble situé dans la paroisse de St-Sauveur, dans la cité de Québec, connu et désigné comme étant le lot numéro deux cent cinquante-cinq (255) du cadastre officiel de la paroisse de St-Sauveur, Québec, avec maison dessus construite, circonstances et dépendances, la maison y érigée portant les numéros municipaux 657-659 rue St-Vallier, Québec.\" L'immeuble ci-dessus désigné est mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur le 30 NOVEMBRE 1949, à ONZE heures de l'avant-midi, heure avancée au bureau du pro-tonotairc, Palais de Justice, Québec.\" Sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de la dite Cour, et que toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à la dite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de la dite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication et, à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans le délai prescrit par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Québec, ce 22 octobre 1949.Les Procureurs de la demanderesse, Mark Drouiv, Ross Drouiv & Lebel.25993-43-2-o NOTICE OF LICITATION Canada, Province of Quel>ec, District of Quebec Superior Court Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting at Quebec, district of Quebec, on October 22nd, 1949, in a case wherein Miss Elise Lamothe is plaintiff, ordering the licitation of certain immovable described as follows, to wit: \"An immovable situated in the Parish of St.Sauveur, in the city of Quebec, known and designated as being lot number two hundred fifty-five (255) on the official cadastre for the Parish of St.Sauveur, city of Quebec, with the house thereon erected, circumstances and dependencies, the house thereon erected bearing municipal numbers 057-659 St.Vallier St.Quel>ec.\" The above described immovable will be sold by auction and adjuged to the highest and last bidder, on the 30th day of NOVEMBER 1949, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time), at the office of the Prothonotary, in the Court House, Quelle.Subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the said Court; and that any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to l>e made to the said licitation, must be filed in the office of the Prothonotary of tla-said Court at least twelve days !>efore the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and that any opposition for payment must be filed within six days after the adjudication: and.failing the parties to file the said oppositions wjthin the delay hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Quebec, October 22nd 1949.Mark Drouin, Ross Drouin & Lebel, Attorneys for Plaintiff.25993-43-2-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 1919, Vol.81, No.|| 2555 Ventes pour taxes Province de Québec ClTÉ de ChICOUTIMI Avis public, est, par les présentes, donné que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du 26 octobre 1949, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chap.207), de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à lu cité de Cliicoutimi et à la Commission scolaire, avec intérêt et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle de la Fanfare, à l'hôtel de ville, le TRENTE NOVEMBRE 1949, à ONZE heures de Pavant-midi.Toutefois pourront être exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales pour l'année 1948 et les taxes scolaires de l'année 1948-1949 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.1.\u2014 Brique de Chicoutimi.\u2014 Les lots de terre 1179-2 et 1177-1 avec droit à l'usage à perpétuité d'une lisière de terrain de 60 pieds de largeur pour communiquer du dit lot no 1179-2 à la nouvelle rue Taché, laquelle lisière de terrain est maintenant désignée sous le no 1179-1.Mais avec réserve en faveur de la Société d'Eclairage et d'Energie Electrique du Saguenay du droit de laisser, maintenir et entretenir à l'endroit où elle se trouve actuellement une première ligne de transmission traversant: a) sur un poteau le lot no 1179-2 et b) sur un autre poteau, le no 1177-1; une seconde ligne de transmission (feeder) traversant, sur deux poteaux, le même 1177-1.2.\u2014 Brassard, Paul-Emile.\u2014 Un terrain ou emplacement formé de la totalité du lot no 608-4 et de la juste moitié ouest du lot no 608-5.3.\u2014 Girard, Joseph.\u2014 Tout ce lopin de terre ou emplacement, formant partie des lots connus et désignés sous les numéros 447, 448 et 449 lequel terrain mesure 46 pieds de largeur de l'ouest à l'est, sur 95 pieds de profondeur, du nord au sud, et est borné: vers le nord, par le terrain réservé pour la rue Price, vers l'est, par le terrain de Alphonse Fortier ou représentants, vers le sud, par le terrain des héritiers Savard ou leurs représentants, et vers l'ouest, par le terrain de Johnny Brassard, fils d'Abel.4.\u2014 Laberge, Charles.\u2014 Le lot numéro 891-20.5.\u2014 Paré, Jacques; L'Heureux, Armand.\u2014 Tout ce lopin de terre ou emplacement formant partie du lot no 407.mesurant 45 pieds de l'est à l'ouest, en front sur la rue Price, par 100 pieds de profondeur, du nord au sud, et est compris dans les bornes suivantes: au nord, par la rue Price, au sud par le terrain de M.F.-X.Bou-dreault, à l'ouest par le terrain de M.Gérard Gagnon, et à l'est par la propriété de M.Armand L'Heureux.Avec le droit de passer à pieds, en voitures et de toutes façons, dans un chemin de 10 pieds de largeur sur toute la profondeur pour communiquer de son terrain à la rue Price.Ledit chemin étant situé sur la limite est du terrain plus haut décrit; le dit chemin étant mitoyen avec M.Armand L'Heureux.Le dit chemin devant être entretenu par les deux parties.6.\u2014 Tremblay, Léonce.\u2014 Tout ce terrain ou emplacement connu et désigné sous le numéro 600-1.7.\u2014 Tremblay, Dame Jules-R.\u2014 Un terrain étant la plus grande partie du lot numéro 297, mesurant 120 pieds de front, sur la rue Racine et borné vers le nord par la ligne sud de la rue Racine, versl'est par M.Jules-H.Tremblay, résidu du lot no 297, vers le sud-est par le Ruisseau de la Prison et vers l'ouest partie au terrain de Dame Johnny Gravel et partie au terrain de MM.Tremblay 4 Frère ou représentant.8.\u2014 Tremblay, Jules-R.\u2014 1.Un lopin de terre formant partie du lot no 297, mesurant 16 pieds de largeur ou environ de l'est à l'ouest, sur la profondeur qu'il y a entre la rue Racine au nord et la ligne centrale d'un ruisseau appelé \"Ruisseau de la Prison\" au sud, et borné vers I est au terrain de la Compagnie Tremblay & Simard, Ltée, ou représentants et vers l'ouest à une ligne parallèle à la limite ouest du dit lot no 297 et distante de 120 pieds, mesure précise de cette ligne ouest; sauf à distraire les droits de passage en faveur de M.Adrien Gagnon et Tremblay Frère; Sales for Taxes Province of Quebec City of Chicoutimi Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated October 26, 1949, has ordered the undersigned, in conformity with the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, chapter 207), to sell the immovables hereinunder designated for payment of arrears of taxes due the City of Chicoutimi and to the School Commission, with interest and costs, and that consequently, the said immovables will be sold by public auction in the Band Hall (salle de la Fanfare) at the city hall, on NOVEMBER, the THIRTIETH, 1949, at ELEVEN o'clock in the forenoon.However, there will be excluded from the sale, those immovables upon which municipal taxes for the year 1948 and school taxes of the year 1948-49, and the preceding years, shall have been paid before the time of sale.1.\u2014 Brique de Chicoutimi.\u2014 Lots of land 1179-2 and 1177-1, with right, in perpetuity, to the use of a strip of land of 60 feet in width, to communicate from said lot 1179-2 to the new Taché street, said strip of land now being designated under No.1179-1.But with reserve, in favour of the \"Société d'Eclairage et d'Energie Electrique du Saguenay\", of the right to leave, maintain and keep in repair, at the place where it is actually found, a first transmission line crossing: a) on a pole, lot No.1179-2 and 6) on another pole, No.1177-1; on a second transmission line, (feeder) crossing on two poles, the said 1177-1.2.\u2014 Brassard, Paul-Emile.\u2014 A lot of land or emplacement formed of the whole of lot No.608-4, and the exact half of lot No.608-5.3.\u2014 Girard, Joseph.\u2014 All that parcel of land or emplacement forming part of those lots known and designated under numbers 447, 448 and 449, said lot of land measuring 46 feet in width from west to east, by 95 feet in depth from north to south, and being bounded: on the north by the land reserved for Price Street, on the east by the land of Alphonse Fortier or representatives, on the south by the land of the Savard heirs or their representatives and on the west by the land of Johnny Brassard, son of Abel.4.\u2014 Laberge, Charles.\u2014 Lot number 891-20.5.\u2014 Paré Jacques; L'Heureux, Armand.\u2014 All that parcel of land or emplacement forming part of lot No.467, measuring 45 feet from east to west, in front, on Price Street, by 100 feet in depth from north to south, and being comprised within the following boundaries: on the north by Price Street, on the south by the land of Mr.F.X.Boudreault, on the west by the land of Mr.Gérard Gagnon, and on the east by the property of Mr.Armand L'Heureux.With right of way on foot and in vehicle, and otherwise in a road of 10 feet in width by the whole of the depth to communicate from his lot of land to Price Street, the said road being situate on the eastern limit hereinabove described; said road being \"mitoyen\" with Mr.Armand L'Heureux.Said road to be maintained by both parties.6.\u2014 Tremblay, Léonce.\u2014 All that lot of land or emplacement known-and designated under number 600-1.7.\u2014 Tremblay, Dame Jules It.\u2014 A lot of land being the greatest part of lot number 297, measuring 120 feet in front, on Racine street and bounded on the north by the south line of Racine Street, on the east by Mr.Jules R.Tremblay, residue of lot No.297, on the southeast by the \"Ruisseau de la Prison\" and on the west partly by the land of Dame Johnny Gravel and partly by the land of Messrs.Tremblay et Frère or representative.8.-*- Tremblay, Jules R.\u2014 1.A parcel of land forming part of lot No.297, measuring 10 feet in width (or about) from east to west by the depth existing between Racine street on the north and the central line of a stream called \"Ruisseau de la Prison\" on the south, and bounded on the east by the land of the \"Compagnie Tremblay & Simard, Ltée\" or representatives and on the west by a line parallel to the west limit of said lot No.297 and 120 feet distant, exact measurement, from this west line; save to be deducted the rights of way in favour of Mr Adrien Gagnon and Tremblay et Frère; « 2£56 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 1919, Tome 81, N° U 2.\u2014 Un terrain formant partie du même lot no 297 de figure irrégulièro et de superficio inconnue, borné vers le nord-ouest, à la ligne centrale du dit ruisseau de la Prison, au sud, partie au terrain ci-après décrit et partie au terrain de MM, Tremblay et Frère et a l'est au terrain de Simard et Tremblay, Ltée, ou représentants; tauf à distraire les droits de passage en faveur de M.Adrien Gagnon et Tremblay et Frère; 3.\u2014 LTn terrain formant partie «lu lot no 317, de figure triangulaire et de superficie inconnue, borné au nord au terrain ci-dessus décrit nu paragraphe 2, au sud-est au terrain de MM.Tremblay et Frère et vers l'ouest au terrain des susdits Tremblay et Frère.9.\u2014 Tremblav, Edgar.\u2014 1.Les lots nos 1150 et 1195-1; 2.Tout ce terrain.ou emplacement, formant partie du lot connu et désigné sous le numéro 1155, mesurant 50 pieds de largeur du nord-est au sud-ouest, sur 120 pieds de profondeur et compris dans les bornes suivantes: vers le nord-ouest à la rue St-Ignaec, bornée des autres côtés h M.Denis Desgagné, ou représentants, le côté nord-est se trouvant à 148 pieds en mesurant sur le chemin public, de l'emplacement de M.Francois .Maltais, ou représentants, le côté sud-est de l'emplacement ci-dessus décrit, se trouvant â 154 pieds de l'angle sud-ouest, formé par la clôture de M.Maltais, ou représentants, à environ une centaine de pieds du chemin public.3.Un emplacement formant partie du lot no 1155, située au nord-est de l'emplacement sus-décrit, sur une largeur de 10 pieds, en mesurant sur le chemin public, sur toute la profondeur du dit emplacement, laquelle lisière de terrain est bornée vers le nord-ouest par le chemin public (rue St-Ignace) vers le nord-est par le terrain de Denis Desgagné, ou représentants, vers le sud-est encore par le terrain de Denis Desgagné, ou représentants, vers le sud-ouest au terrain susdécrit en premier lieu.10.\u2014 Tremblay, J.David.\u2014 Ce lopin de terre ou emplacement connu sous le numéro 044-22, sauf i\\ distraire: a) Une partie comprise dans 1 angle nord du dit lot et délimitée par les lignes limitatives nord-est et nord-ouest et un arc de cercle d'un rayon de quinze pieds; b) Une lisière d'une profondeur de 5 pieds sur toute la largeur comprime entre l'arc de cercle décrit en premier lieu et la ligne limitative sud-ouest du ditdot et bornée vers le nord-ouest par le lot no 045 (rue Caron).L'acquéreur ou ses représentants ne pourront ériger, bâtir, ou placer aucune bâtisse ou partie de bâtisse ou habitation plus près de 10 pieds des lignes séparât ives du dit lot no 044-22 avec les lots de rues nos 045 et 644-26.11.\u2014 Tremblay, Thomas et Tremblay, Philippe \"Ma-thias\".\u2014 Un lopin de terre mesurant 50 pieds de profondeur du nord au sud par 54 pieds de largeur de l'est à l'ouest, formant partie du lot no 001-7, compris dans les bornes suivantes: vers le nord au terrain formé du lot no 601-8, vers le sud au terrain de Ths Tremblay ou représentant, vers l'est à Léonce Tremblay et vers l'ou3st à Léger Lachance.Avec droit pour l'acquéreur et bjs représentants du droit de poser des portes, fenêtres, chassis et droit de vue sur le résidu du lot no 001-7, et ce quelque soient les distances des constructions qui pourront être érigées.Les dits lots et parties de lots sont du cadastre officiel de la ville de Chicoutimi.Us seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en a, sujet à tous les droits acquis de la cité de Chicoutimi et à toutes less ervitudes actives ou passives apparentes ou occultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette aux dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Chicoutimi, ce 28 Octobre 1949.Le Greffier, 26027-44-2-o GASTON CARRIER.VLLLE DE LAUZON Vente de propriétés pour taxes Avis public est par les présentes donné que les iropriétés ci-dessous désignées seront vendues à 'enchère à l'Hôtel de Ville de Lauzon, MER- 2.A lot of land forming part of said lot No.207 of irregular and unknown superficial arai, bounded on the north west by the central lino of said \"Ruisseau de la Prison\", on the south partly by the land hereinafter described and partly by tho land of Messrs.Tremblay et Frère, and on tho east by tho land of Simnrd & Tremblay, Ltée or representatives; save to he deducted the rights of way in favour of Mr.Adrien Gagnon and Tremblay et Frère; 3.A lot of land forming part of lot No.317, of irregular figure, and unknown superficial area, bounded 00 the north by the land hereinabove described in paragraph 2, on the southeast by the land of Messrs 11cm-May et Frère and on the south by the land of aforesaid \"Tremblay et Fiîre\".0.\u2014 Tremblay, Edgar.\u2014 1.Lots Nos 115(1 and 1 l'Jô- 1; 2.All that lot of land or emplacement forming part of that lot known and designated under number 1105, measuring 50 feet in width from the northeast to thé southwest, by 120 feet in depth, and comprised within the following boundaries: on the northwest bySt-lgnace Street, bounded on the other sides by Mr.Denis Desgagné or representatives, the northeast side being 1 Is feet measured on the public toad from the emplacement of Mr.François Maltais or representatives, the southeast side of the emplacement hereinabove described being 154 feet from the southwest angle forme I by the fence of Mr.Maltais or representatives, at about one hundred feet from the public road.3.An emplacement forming part of lot No.115a.situate on the northeast of the hereinabove described mi-placement, on a width of 10 feet, measuring on the public road by the whole depth of the said emplacement, said strip of land being bounded on the north-west by the public road, (St-Ignace Street) on the northeast by the land of Denis Desgagné or representatives, on the southeast, again by the land of Denis Desgagné or representatives, on tho southwest by thé land hereinabove firstly described.10.\u2014 Tremblay, J.David.\u2014 That parcel of land or emplacement known under number 044-22, sue to be deducted: a) A part c unpriscd in the north angle of said lot, and limited by the following northeast and northwest boundary lines and the arc of a circle of a radiai of fifteen feet; 6) A strip of land of five feet in depth by the whole of the width of the arc of'a circle firstly described and the southwest boundary line of said lot and bounded on the notthwest by lot No.645 (Caron Street).The purchaser or representatives thereof may not erect, build or place any building or part of building or dwelling closer than 10 feet from the lines dividing said lot No.644-22 from streets lots of Nos.645 and 64 l-Jti.11.\u2014; Tremblay, Thomas and Tremblay Philippe \"Mathias\".\u2014 A parcel of land measuring 50 feet in depth from north to south by 54 feet in width from east to west, forming part of lot No.601-7, comprised within the following boundaries: on the north by the loi of land composed of lot No.601-8, on the south by the land of Ths.Tremblay or representative, on the east by Léonce Tremblay and on the west by Léger Lachance, with right for the purchaser and his representatives, to put up doors, sashes, windows, and right of way on the residue of lot No.601-7, and such, whatever be the distance of the constructions which may be erected.The said lots or parts of lots arc of the official cadastre for the town of Chicoutimi.They will be sold with buildings thereon erected circumstances and dependencies if any, subject to all acquired rights of the city of Chicoutimi, and to all active and passive, apparent or unap-parent servitudes which may affect the same.The purchase price of each of these immovables shall be payable immediately.The sale shall, moreover, be subject to the provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at Chicoutimi, October 28, 1949.GASTON CARRIER, 26027-44-2 Clerk.TOWN OF LAUZON Sale of Property for Taxes.Public notice is hereby given that the properties hereinbelow described will be sold at public auction in the Town Hall of Lauzon, on WED- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 1949, Vol.81, No.4A 2557 CREDI, le QUATORZE DECEMBRE 1949, a DIX heures de l'avant-midi en vertu des articles 518 et suivants du chapitre 243 des statuts refondus de la Province de Québec de 1941.La Commission Municipale de Québec, par décision en date du 1er octobre 1949, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles sous l'autorité «le la Loi des Cités et Villes, article 550, tel qu'amendé par la Loi 24, Geo.V, chap.33, sections 3 et 5 Geo.VI, chap.41, section 13.NESDAY, the FOURTEENTH day of DE-CEMBER, 1949, at TEN o'clock in the forenoon, pursuant to sections 548 and following of chapter 243 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941.The Quebec Municipal Commission, by a decision dated the 1st of October, 1949, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immovables under authority of the Cities and Towns Act, section 550, as amended by the Act 24 Geo.V, chap.33, sections 3 and 5 Geo.VI, chap.41, section 13.\tNoms Names\t\u2022\tNo.cad.Cad~No.\tSubd.1\u2014J.S.DeBilly.\t\t\t739\t2 Pour le Village incorporé de Lauzon.For the Incorporated village of Lauzon.2- Honoré Dubreuil.Au cadastre revisé du quartier Couture de Lauzon.I 150 I 1 Revised cadastre for Couture Ward, Lauzon.3\u2014J.S.DeBilly.4\u2014J.S.DeBilly.5\u2014Levis Dry Dock Co.C\u2014 Levis Dry Dock Co.7\u2014Levis Dry Dock Co.S\u2014Levis Dry Dock Co.Au cadastre officiel pour la partie est du village incorporé de Lauzon.200\t119 205\t69 204\t325-A 203\t\"A\" 203\t\"B\" 203\t»&> Of the official cadastre for the east part of the incorporated village of Lauzon.I 77 I 9\u2014Dominion Investment Co.I Au cadastre officiel pour le village incorporé de St- Of the official cadastre for the incorporated village Joseph do Levis.of St-Joseph de Levis.La dite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes attachées aux dits immeubles.Condition de la vente: argent comptant ou chèque revisé par la Banque.Donné à l'Hôtel de Ville de Lauzon, ce vingt-septième jour d'octobre 1949.Le Greffier, 2G039-44-2-o L.BOURASSA.The said sale shall, moreoever, be made with all the active and passive, apparent and unap-parent servitudes attached to the said immovables.Conditions of sale : cash or cheque certified by a bank.(liven at the Town Hall of Lauzon, this twenty-seventh day of October, 1949.L.BOURASSA, 26039-44-2 Clerk.VENTES PAR SHÉRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Province de Québec, ( T\\0 M I N I K MIKO-District d'Abitibi, ) LICH, épicier de la Cour Supérieure, \\ Ville de Malartic, district N°V-1435 (d'Abitibi, contre MAURICE PINARD, mineur de la ville de Malartic district d'Abitibi, à savoir les lots Nos 244 et 245 du bloc 3 du canton Fournière, avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances, avec les servitudes actives et passives, sans exception ni réserves.Pour être vendu à la porte de l'édifice ou se tient les offices religieux à Malartic district d'Abitibi le VENDREDI NEUF DÉCEMBRE 1949 à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos 29 octobre 1949.26029-44-2-o [Première insertion: 5 novembre 1949] PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LAND and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province of Quebec, /TV) M I NIK MLKO-District of Abitibi, ) LICH, grocer, of the Superior Court, \\ town of Malartic, district No.V-1435 ' of Abitibi; against MAURICE PINARD, miner, of the town of Malartic, district of Abitibi, to wit: lots Nos.244 and 245 of Block 3 of the township Fournière\u2014with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, with the active and passive servitudes, without any exception or reserve.To be sold at the door of the building where religious services are held at Malartic, district of Abitibi.on FRIDAY, DECEMBER NINE, 1949, at ELEVEN o'clock in the forenoon.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, October 29, 1949.26029-44-2 First insertion: November 5, 1949] 2558 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 novembre 1919, Tome 81, N° U Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour de Magistrat, j OROTEAU & FRERES N° 9340 j ^ LIMITEE, corps politique et incorporé ayant son principal siège d'affaire à Amos, district d'Abitibi, demandeur, vs ROMEO LEBLOND, de Senneterre, district d'Abitibi, défendeur.Comme appartenant au défendeur le lot connu et désigné au plan et livre de renvoi du cadastre officiel du village de Senneterre comme étant le N° 6 du bloc 79, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Senneterre, le MTRCREDI, 14 DECEMBRE 1949, à DIX heures de l'avant-midi.lie Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, 2 Novembre 1949.26040-44-2-o (Première insertion: 5 novembre 1949] ARTHABASKA Cour Supérieure séant en matière de faillite, N° 39F Vente en exécution d'une ordonnance rendue par l'Honorable Juge Wilfrid Girouard, suivant article 45, chapitre 11, S.R.C.1947.Dans l'affaire de HENRI LEROUX, garagiste, de la paroisse de St-Paul de Chester.Cédant autorisé.Un terrain ou emplacement situé sur le coté sud du chemin de St-Philippe, dans la paroisse de St-Paul de Chester, connu et désigné au cadastre de la paroisse de St-Paul de Chester, comme faisant partie du numéro 13 (p.13), de figures irrégulière, avec un hangar à deux étages, de 30 pieds de largeur sur 80 pieds de longueur, le tout plus ou moins renfermé dans les bornes suivantes; En front au chemin de St-Philippe, en arrière aux murs du hangar précité d'un cé)té à 10 pieds de la galerie de Paul Lyonnais, et de l'autre côté à partir du coin du hangar à aller à 45 pieds du côté du chemin public, à un poteau planté dans le sol, et de ce poteau, 25 pieds à aller du hangar d'Octave Lafontaine, avec les réserves et les droits mentionnés dans cet acte de vente passé devant Mtre C.R.Garncau, notaire d'Arthabaska, le 22 septembre 1948, et enregistré sous le numéro 98994 du bureau d'enregistrement d'Arthabaska; Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Paul de Chester, comté d'Arthabaska, le QUINZIEME jour de NOVEMBRE 1949, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, MAURICE MAHEU.Arthabaska, 11 octobre 1949.25907-4 l-2-o [Première insertion : 15 octobre 1949] Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Magistrate's Court ( OROTEAU & FRERES No.9340 ) V-> LIMITÉE, a body politic and corporate, having its head office at Amos, district of Abitibi, plaintiff; vs ROMEO LE-BLOND, of Senneterre, district of Abitibi, defendant.As belonging to the defendant.The lot known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the village of Senneterre, as being No.6 of Block 79 \u2014 with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Senneterre, on WEDNESDAY, the FOURTEENTH of DECEMBER, 1949, at TEN o'clock in the forenoon.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, November, 2, 1949.26040-44-2 [First insertion: November 5, 1949] ARTHABASKA Superior Court sitting in Bankruptcy, No.39F Sale executing an Order rendered by Honourable Justice Wilfrid Girouard, pursuant to section 45, chapter 11, R.S.C.1947.In the matter of HENRI LEROUX, garage-keeper, of the parish of St.Paul de Chester, Authorized Assignor.A lot of land or emplacement situate on the south side of the St-Philippe road, in the parish of St.Paul de Chester, known and designated on the cadastre for the parish of St.Paul de Chester as forming part of lot number 13 (Pt.13), of irregular figure, with a two storey shed of 30 feet in width by 80 feet in length, the whole more or less, enclosed within the following boundaries: in front by the St-Philippe road, in rear by the walls of the aforesaid shed, on one side, 10 feet distant from the gallery of Paul Lyonnais, and on the other side, starting from the corner of the shed up to 45 feet from the side of the public road, to a post planted in the ground, and from said post 25 feet as far as the shed of Octave Lafontaine with the reserves and rights mentioned in that deed of sale passed l>efore Mtre C.R.Garneau, notary, of Arthabaska, on September 22, 1948, and registered under number 98994, of the Registry Office of Arthabaska.To be sold at the church door of the parish of St.Paul de Chester, county of Arthabaska, on the FIFTEENTH day of NOVEMBER, 1949, at TWO o'clock in the afternoon.MAURICE MAHEU, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, October 11, 1949.25907-41-2 [First insertion: October 15, 1949] BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Dans la Cour Supérieure, District de Beauce St-Joseph de Beauce, / A RCHELAS BOU-à savoir: { LANGER de St-N° 20,607 I Gédéon de Beauce, contre JEAN-BAF1TSTE MARQUIS de St-Gédéon de Beauce, à savoir: Le lot numéro vingt-trois A et une partie du lot numéro vingt-trois B du rang cinq du canton de Marlow, en le comté de Beauce, borné BEAUCE Fieri Fadas de Bonis et de Terris In the Superior Court, District of Beauce St-Joseph de Beauce, i A RCHELAS BOH-towit: LANGER, of St- No.20,607 \\ Gédéon de Beauce; a- gainst JEAN-BAPTISTE MARQUIS, of St-Gédéon de Beauce, to wit: Lot number twenty-three-A and part of lot number twenty-three-B of range five of the township of Marlow, in the county of Beauce, 4 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, November 5th, 10A9, Vol.81, No.U 2506 \u2022 au nord-ouest à François Mercier, et au sud-est à Roland Pelchat, au nord-est au chemin de front (tt Wl sud-ouest au trécarré dudit rang, avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances, tel que le tout est actuellement avec les servitudes actives et passives, sans exception ni réserve.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale, en la paroisse de St-(îédéon de Beauce, le DOUZIEME jour «le DECEMBRE prochain à DIX heures «le l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, 2 novembre 1949.26035-44-2^) .[Première insertion: 5 novembre 1949] [Seconde insertion: 12 novembre 1949] bounded on the northwest by François Mercier, ami on the southeast by Roland Pelcbat, on the northeast by the front road, ami on the southwest by the \"trécarré\" of said range\u2014with buildings thereon erect«'«l, circumstances and dependencies, as the whole actually subsists, with the active and passive servitudes, without any exception or reserve.To be sold at the parochial church d«j«>r of the parish of SMiédëon de Beauce on the TWELFTH
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.