Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 avril 1950, samedi 29 (no 17)
[" Tome 82, N° 17 * 1225 Vol.82.No.17 (Drapeau de la province de Québec, adopte par arrêté eu conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flag of the Province of Quebec, adopted by order in Council Number 72, bearing date January 21st, 1048 ) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 29 a vim, 1950 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlement! 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il v a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7e La Qatette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday; April 29th, 1950 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at tho cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions 4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 1226 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1960, Tome 89, N° 17 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéresses sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chif-fies, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions : $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439-1-52 Lettres patentes Bibliothèque de Chicoulimi Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la» province de Québec, des lettres patentes, en date du six mars 1950.constituant en corporation sans capital-actions: Dame Marguerite Aubin-Tcllier, épouse contraetuellcment séparée de biens de Paul Tellier, vice-président et gérant général de la Cie Electrique du Sague-nay, Dame Marguerite Lavoie-Boivin.épouse contraetuellcment séparée de biens de G.-E.Boivin, notaire, et Dame Anita Belleau-Pelletier, épouse contraetuellcment séparée de biens de Jean Pelletier, C.R., toutes des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Aider au.dévelcppcment religieux, moral, et intellectuel de la population par le moyen de bibliothèques, sous le nom de \"Bibliothèque de Chicoutimi\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Letters Patent Bibliothèque de Chicoutimi Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March.1950, to incorporate as a corporation without share capital: Dame Marguerite Aubin-Tcllier, wife separate as to property by marriage contract of Paul Tellier, Vice president and general manager of the Cie Electrique du Sague-nay, Dame Marguerite Lavoie-Boivin, wife separate as to property by marriage contract of C.-E.Boivin, notary, and Dame Anita Belleau-Pelletier, wife separate as to property by marriage contract of Jean Pelletier, K.C., all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To help the religious, moral and intellectual development of the pupulation by means of libraries, under the name of \"Bibliothèque de Chicoutimi\".The amount to which the immovable property which the corporation mav hold is to be limited, is §50,000.00. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1227 Le siège social de la corporation sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le six mars 1950.L*Assistant-procureur général, 27320-o L.DÉSILETS.The head office of the corporation will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329 Deputy Attorney General.Campbell Chibougamau Mines Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières tie Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix mars 1950, constituant en corporation: René Chênevert, procureur, de la cité de West-mount, Mario Emiliano Lattoni, procureur, de la cité de Montréal, et Isabelle Macfarlane, sténographe, fille majeure, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Campbell Chibougamau Mines Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de §3,000,000 divisé en 3,000,000 d'actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu de payer à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera h Montréal, district judiciaire de Montréal.\u2022 Daté du bureau du Procureur général, le dix mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.Cash Register Importers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes en date du huit mars 1950, constituant en corporation: Dave Friedman, Hyman Friedman, gérants, et John DesBarres Jennison, procureur, d'Ottawa et les deux premiers des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et vendre de l'ameublement de bureau de toutes sortes, sous le nom de \"Cash Register Importers Ltd.\", avec un capital de $90,000 divisé en 100 actions ordinaires de SI00 chacune et en 800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.\u2022 C.E.Durette Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix mars 1950, constituant en corporation: Campbell Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March, 1950, incorporating: René Chênevert, barrister, of the City of West-mount, Mario Emiliano Lattoni, barrister, of the City of Montreal, and Isabelle Macfarlane, stenographer, spinster, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all oj>erations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purposes of extracting any minerals whatsoever, l>e mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Campbell Chibougamau Mines Ltd.\"\" (No Personal Liability), with a capital stock of $3,-000,000 divided into 3,000,000 shares of the par value of $1.each.The shareholders will incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares; The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-0 Deputy Attorney General.Cash Register Importers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day df March, 1950, incorporating: Dave Friedman, Hyman Friedman, managers, and John DesBarres Jennison, barristcr-at-law.of Ottawa, and the two former of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and sell office equipment of all kinds, under the name of \"Cash Register Importers Ltd.\", with a capital stock of $90,000.divided into 100 common shares of S100 each, and 800 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-o Deputy Attorney General.C.E.Durette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March, 1940, incorporating: Charles Eugène 1228 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, Nû 17 Charles-Eugène Durette, industriel, de Escourt, Robert Thébergc, industriel, de St-Eleuthère, tous deux du district judiciaire de Kaniouraska, et Raymond Déry, industriel, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce communément connu et désigné sous le nom de \"Service de Toilette\", sous le nom de \"C.E.Durette Limitée\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions-de $100 chacune.Ixî siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329-0 L.DÉSILETS.Conovn Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze mars 1950, constituant en corporation: Harry Bernard Zarr, marchand, Abraham Jacob Rosenstein et Eric Hyman Feigelson, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands et négociants de dispositifs, appareils et accessoires électriques, sous le nom de \"Conova Corporation Ltd.\" Le capital de la compagnie est divisé en 1,000 actions sans valeur nominale ou au pair et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune, et le montant avec lequel la compagnie exercera son commerce ne sera pas moins que $7,000.00.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L DÉSILETS.Cowan Goodridgc Standard Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept mars 1950, constituant en corporation: Harry Arnold Cowan, manufacturier, Benjamin L.Louis et Edward S.Berger, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à dessiner, manufacturer, vendre et réparer de la machinerie et outillage de toutes sortes, sous le nom de \"Cowan Goodridgc Standard Company\", avec un capital de $40,000 divisé en 2.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S5 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune connues et désignées comme étant \"des actions privilégiées catégorie \"B\" et en 4,000 actions privilégiées catégorie \"A\" d'une valeur au pair de 85 chacune.siège social de la compagnie sera à Valley-field, district judiciaire de Beauhamois.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.Gelfine Fur Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Durette, industrialist, of Escourt, Robert Thé-berge, industrialist, of St-Elcuthère, both of the judicial district of Kamouraska, and Raymond Déry, industrialist, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business commonly known and designated as \"Toilet Service\", under the name of \"C.E.Durette Limitée\", with a capital stock of $100.000 divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montréal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329 Deputy Attorney General.Conova Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letter patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of March, 1950, incorporating: Harry Bernard Zarr, merchant, Abraham Jacob Rosenstein and Eric Hyman Fcigclson, advocates, of.the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturer and dealers in and with electric appliances, apparatus and* accessories, under the name of \"Conova Corporation Ltd.\".The capital stock of the company is to be divided into 1,000 shares having no nominal or par value and 400 preference shares at a par value of $50.each, and the amount with which the company will carry on its operations will be not less than $7,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Date at the office of the Attorney General this eleventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-0 Deputy Attorney General.Cowan Goodridgc Standard Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1950, incorporating: Harry Arnold Cowan, manufacturer, Benjamin L.Louis and Edward S.Berger, advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry un the business of designing, manufacturing, selling and servicing machinery and equipment of all kinds, under the name of \"Cowan Goodridgc Standard Company\", $40,000.divided into 2,000 common shares of the par value of $5.each, and 2,000 preferred shares of the par value of $5.each, to be known and designated as \"preferred shares Class B\" and 4,000 preferred shares Class \"A\" of a par value of $5.each.The head office of the Company will be at Valleyfield, Judicial District of Beauhamois.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27320-o Deputy Attorney General.Gclfine Fur Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April H9th, 1950, Vol.82, No.17 1229 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze mars 1950, constituant en corporation: Henry L.Silvcrstonc, avocat, David Finestone, comptable agréé et Doris Star, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de fourrures, sous le nom de \"Gclfine Fur Co.Inc.\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 407 ouest, rue Ontario, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.Gladstone Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quelle, des lettres patentes en date du dix mars 1950, constituant en corporation: Joseph Marder, expéditeur, William Gladstone, vendeur, et Dame Lily Slutsky, épouse séparée de biens de William Gladstone et dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer ou autrement faire le négoce et le commerce d'articles, objets et marchandises composés en tout ou en partie de textiles, plastiques, bois, métaux ou de leurs produits ou sous-produits, sous le nom de \"Gladstone Sales Inc.\", avec un capital de 85,000 divisé en 500 actions d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mars 1950.L'Assistant-procureur général.27329 L.DÉSILETS.Hamel Asphalte Construction Ltée Hamel Asphalt Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quélwc des lettres patentes, en date du sept' mars 1950, constituant en corporation: Yvon Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau et Rita Dufresne, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Hamel Asphalte Construction Ltée\" \u2014 \"Hamel Asphalt Construction Ltd.\", avec un capital de S40.000, divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laval-des-Rapides, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept mars 1950.L'Assistant-procureur général.27329-0 L.DESILETS.Hartman Textiles Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze mars 1950, constituant en corporation: Albert Malouf, avocat, Paul-Arthur.Vallée, been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of March, 1950, incorporating: Henry L.Silvcrstonc, advocate, David Finestone, chartered accountant, and Doris Star, secretary, fille majeure, all of the City nnd Judicial District of Montréal, for the following purposes: To carry on business as furriers, under the name of \"Gelfinc Fur.Co.Inc.\", with a capital stock of 830,000.divided into 300 common shares of 8100.00 each.The head office of the Company will be at 407 Ontario St.West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-0 Deputy Attorney General.Gladstone Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, l>earing date the tenth day of March, 1950, incorporating: Joseph Marder, shipper, William Gladstone, salesman, and Dame Lily Slutsky, wife separate as to property of William Gladstone, and duly authorized by him, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture or otherwise deal in and with goods, wares and merchandise composed in whole or in part of textiles, plastics, wood, metal or the products or by-products thereof, under the name of \"Gladstone Sales Inc.\", with a capital stock of 85.000 divided into 500 shares of the par value of 810.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-0 Deputy Attorney General.Hamel Asphalte Construction Ltée Hamel Asphalt Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1950, incorporating: Yvon Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau and Rita Dufresne, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in building materials, under the name of \"Hamel Asphalte Construction Ltée\" \u2014 \"Hamel Asphalt Construction Ltd.\" with a capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Laval-des-Rapides, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329 Deputy Attorney General.Hartman Textiles Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of March, 1950, incorporating: Albert Malouf, advocate, Paul-Arthur Vallée, advocate and 1230 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 avocat et conseil en loi du Roi et Claire Lapointe, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements, sous le nom de \"Hartman Textiles Limited\", avec un capital de S20.000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.II.L.Ironcraft Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mars 1950, constituant en corporation: Léo Davignon, comptable, Gérard Corbeil, avocat, et Raymond Laçasse, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de métaux, sous le nom de \"H.L.Ironcraft Co.Ltd.\", avec un capital de $60,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune, et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329-o I- DÉSILETS.King's Counsel, and Claire Lapointe, stenographer, spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Hartman Textiles Limited\", with a capital stock of $20,000.divided into 1,000 common shares of the par value of $10.each, and 100 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the Office of the Attorney General this eleventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-o Deputy Attorney General.Jean Bourdon Ltcc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1950, constituant en corporation: Jean Bourdon, négociant, Olivette Drouin Bourdon, épouse séparée de biens dudit Jean Bourdon et par lui autorisée aux fins des présentes, Louise Dion Bourdon, veuve de Georges-Henri Bourdon, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivnnts: Sujet aux dispositions de la Loi de Pharmacie de Québec, manufacturer et faire le commerce clc produits chimiques et pharmaceutiques, sous le nom de \"Jean Bourdon Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329-0 L.DÉSILETS.H.L.Ironcraft Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1950, incorporating: Léo Davignon, accountant, Gérard Corbeil, advocate, and Raymond Laçasse, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in metals, under the name of \"H.L.Ironcraft Co.Ltd.\", with a capital stock of $60,000 divided into 400 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthc.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS.27329 Deputy Attorney General.Jean Bourdon Ltée Notice is hereby given that tinder Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1950, incorporating: Jean Bourdon, merchant, Olivette Drouin Bourdon, wife separate as to property of said Jean Bourdon, and duly authorized by him for the purposes hereof, Louise Dion Bourdon, widow of Georges Henri Bpurdon, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: Subject to the provisions of the QucIjcc Pharmacy Act, to manufacture and deal in chemical and pharmaceutical products, under the name of \"Jean Bourdon Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329 Deputy Attorney General.J.E.R.Merge vin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1950, constituant en corporation: René Bergevin, entrepreneur-constructeur, de Saint-Bruno, Edouard Bergevin, gérant de commerce, Robert Bergevin, vendeur, et Jean-Paul Bergevin, négociant, ces trois derniers de la cité de Montréal, J.E.R.Bergevin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March, 1950, incorporating: René Bergevin, contractor and builder, of Saint-Bruno, Edouard Bergevin, business manager, Rol)ert Bergevin, salesman and Jean-Paul Bergevin, merchant, these three latter of the city of Montreal, all of \\ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 20th, 1950, Vol 82, No.17 1231 tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire, réparer et entretenir des immeubles en général, sous le nom de \"J.E.R.Bergevin Inc.\", avec un capital de S 10,000 divisé en -100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329-0 L.DÉSILETS.La Commission Industrielle de St-IIyacinlhc The Industrial Commission of St.Hyacinthe Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date du neuf mars 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Camille Mercure.1.-Eugène Côté, Maurice Augustin, industriels, Franc ris Jette, commerçant, Antonio Breton, opt omet ris-te, et Jacques Bousquet, avocat, tous «les cité et district judiciaire «le Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts matériels de la cité «le Saint-Hyacinthe, sous le nom «le \"La Commission Industrielle «le St-Hycinthe\"\u2014\"The Industrial Commission of St.Hyacinthe\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation j>cut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire «le Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général le neuf mars 1950.L'Assistant-procureur général.27329-Q L.DÉSILETS.the judicial district of Montreal, for the following purposes: To build, repair and maintain immovables in general, under the name of \"J.E.R.Bergevin Inc.\" with a capital stock «>f 840,000.divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day «>f March, 1950.L.DÉSILETS, 27329 Deputy Attorney General.La Commission Industrielle de St-Hyacinthe The Industrial Commission of St.Hyacinthe Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing ec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1950, constituant en corporation: Walter Creighton Leggat, avocat.Mary Hemcns, Ruth Elizabeth Smith, Helen Elizabeth Ralph et Gabriclle Picard, sténographes, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme propriétaires tt exploitants d'une carrière et comme marchands de pierre, sous le nom de \"Shciïord Marble Quarries Limited\", avec un capital de SI50.000 divisé en 14,850 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1950.L'Assistant-procureur général.27329 L.DÉSILETS.Terry Town Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf mars 1950.constituant en corporation: Rudolph Kanigsbcrg.Moe Kanigsbcrg et Abraham Schachter, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements de toute description, sous le nom de \"Terry Town Inc.\".avec un capital de $30.000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 366 rue Mayor, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1950.^ L'Assistant-procureur général.27329 L.DÉSILETS.The Century Aluminum Works Corporation Avis est dunné qu'en vertu de la premières Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1950, constituant en corporation: Armand Fortier, Marcel Toupin, industriels, et Guy Girard, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de métaux et alliages, sous le nom de \"The Century Aluminum Works Corporation\", avec un capital de $19,000 divisé en 190 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté tlu bureau du Procureur général le neuf mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329 Deputy Attorney General.ShcfTord Marble Quarries Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have l>cen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1950, incorporating: Walter Creighton Leggat, advocate, Mary Hemcns, Ruth Elizabeth Smith, Helen Elizabeth Ralph and Gabrielle Pi-card, stenographers, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of quarry owners and operators and stone merchants, under the name of \"Shefford Marble Quarries Limited\", with a capital stock of $150,000.divided into 14.S50 preferred shares of the par value of $10.each, and 1.500 common shares of the par value of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March; 1950.L.DÉSILETS, 27329-o Deputy Attorney General.Terry Town Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March.1950, incorporating: Rudolph Kanigsbcrg.Moe Kanigsbcrg and Abraham Schachter, merchants, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel of any description, under the name of \"Terry Town Inc.\", with a capital stock of $30,000.divided into 100 common shares of a par value of $100.each, and 200 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at 300, Mayor Street.Montreal, Judicial District cf Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1950.L.DÉSILETS.27329-o Deputy Attorney General.The Century Aluminum Works Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March, 1950, incorporating: Armand Fortier, Marcel Toupin, industrialists, and Guy Girard, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in metals and alloys, under the name of \"The Century Aluminum Works Corporation\", with a capital stock of $19.000 divided into 190 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of March, 1950.L.DÉSILETS.27329 Deputy Attorney General. 1236 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 The Latin Quarter Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1950, constituant en corporation: Isidore Popligcr, avocat et conseil en loi du Roi, Lawrence Popligcr, avocat et Raymond J.Ma-houx, restaurateur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme pourvoyeurs et fournisseurs, sous le nom de \"The Latin Quarter Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.The Latin Quarter Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morissct, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-first day of March, 1950, incorporating: Isidore Popligcr, advocate and King's Counsel, Lawrence Popligcr, advocate, and Raymond J.Mahoux, restaurateur, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as purveyors and cate-rors, under the name of \"The Latin Quarter Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of 8100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-o Deputy Attorney General.The Sports Car Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1950, constituant en corporation: John Bumbray, conseil en loi du Roi, de la cité de Mont-Royal, Jean-Paid Cardinal, Jehan Perdriau, avocats, de la cité de Montréal, Madeleine Pépin, secrétaire, de Rosemont et Françoise Caisse, secrétaire, de 'Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et négociants de toutes sortes de véhicules-moteurs, sous le nom de \"The Sports Car Company Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.Unique Frocks Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf mars 1950, constituant en corporation: Samuel Moskovitch, avocat et conseil en loi du Roi, Edith Pomcrantz, sténographe et Sydney Sadcgursky, manufacturier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de robes et autres vêtements, sous le nom de \"Unique Frocks Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2033 rue Bleury, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.The Sports Car Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1950, incorporating: John Bumbray, King's Counsel, of the City of Mount-Royal, Jean-Paul Cardinal, Jehan Perdriau, advocates, of the City of Montreal, Madeleine Pépin, secretary, of Rosemount, and Françoise Caisse, secretary, of Verdun, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes; To carry on business as merchants and dealers in all kinds of motor vehicles, under the name of \"The Sports Car Company Inc.\", with a capital stock of 840,000.divided into 4,000 shares of 810.each.The head office of the Company will l>e at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-0 Deputy Attorney General.Unique Frocks Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March, 1950, iunorporating: Samuel Moskovitch, advocate and King's Counsel, Edith Pome-rantz, stenographer, and Sydney Sadegursky, manufacturer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dresses and other wearing apparel, under the name of \"Unique Frocks Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 100 common shares of a par value of $100.each, and 300 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at 2033 Bleury Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Avril 29th, 1950, Vol.82, No.Il 1237 Vogel Bag Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1950, constituant en corporation: Bernard Fields, marchand, Fred Vogel, marchand, et Jack Pepper, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Négocier, commercer et exercer le commerce qui consiste à manufacturer des sacs, des articles en cuir et de fantaisie et des nouveautés, sous le nom de \"Vogel Bag Corp.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27329 L.DÉSILETS.Vogel Bag Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1950, incorporating: Bernard Fields, merchant, Fred Vogel, merchant, and Jack Pepper, merchant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To trade, deal in, and carry on the business of manufacturing bags, leather and fancy goods and novelties, under the name of \"Vogel Bag Corp.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27329-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Browns Bottle & Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 5 avril 1950, à la compagnie \"Browns Bottle Exchange Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5 juillet 1926, sous le nom originaire de \"L.& M.Browns Co.Limited\", et par lettres patentes supplémentaires en date du 3 novembre 1928, changeant ledit nom originaire en celui de \"M.Browns & Co.Limited\", et par d'autres lettres patentes supplémentaires en date du 12 décembre 1930, changeant le dernier nom en celui susmentionné de \"Browns Bottle Exchange Inc.\", changeant de nouveau le nom de ladite compagnie de \"Browns Bottle Exchange Inc.\" en celui de \"Browns Bottle & Supplies Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 5 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27330 L.DÉSILETS.Jean Picard Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 4 avril 1950, à la compagnie \"J.H.Ayotte Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 mai 1949, changeant son nom en celui de \"Jean Picard Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 4 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27330-o L.DÉSILETS.La Corporation de Téléphone de Québec Quebec Telephone Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 12 avril 1950, à la compagnie \"La Corporation de Téléphone de Québec\" \u2014 Supplementary Letters Patent Browns Bottle & Supplies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 5th day of April?1950, were issued by the Lieutenant-Governor-of the Province of Quebec, to the company \"Browns Bottle Exchange Inc.\", incorporated by letters patent dated July 5th, 1926, under the original name of \"L.& M.Browns Co.Limited\", and by supplementary letters patent dated November 3rd, 1928.changing said original name to \"M.Browns & Co.Limited\", and by further supplementary letters patent dated December 12th, 1930, changing the latter name to the aforementioned name of \"Browns Bottle Exchange Inc.\", again changing the name of the said company from \"Browns Bottle Exchange Inc.\" to that of \"Browns Bottle & Supplies Inc.Dated at the office of the Attorney General, the 5th of April, 1950.L.DÉSILETS, 27330-o » Deputy Attorney General.Jean Picard Limi3ée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the fourth day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"J.II.Ayotte Company Limited\", incorporated by letters patent under date of May 10, 1949, changing its name to that of \"Jean Picard Limitée\" Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27330 Deputy Attorney General.La Corporation de Téléphone de Québec Quebec Telephone Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"La Corporation de Téléphone de Québec\" \u2014 1238 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N\" 17 \"Quebec Telephone Corporation\", ratifiant: 1° son règlement spécial X° 32: a) annulant 13,714 actions catégorie \"A\" non-émises sans valeur' nominale ou au pair; b) convertissant 36,286 actions catégorie \"A\" émises sans valeur nominale ou au pair en 36,286 actions catégorie \"A\" d'une valeur au pair de $15 chacune; c) convertissant les 50.000 actions catégorie \"B\" sans valeur nominale ou au pair en 50,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune; (I) augmentant le nombre d'actions ordinaires de 50,000 à 144,054 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune et e) énumérant les privilèges et restrictions attachés aux actions catégorie \"A\" et aux actions ordinaires; 2° le règlement spécial N° 33 de la compagnie, augmentant son capital-actions autorisé par la création de 50,000 actions privilégiées cumulatives à 5% rachctablcs par fonds d'amortissement d'une valeur au pair de S20 chacune, \u2022 énumérant les privilèges attachés à ces actions privilégiées et fixant le capital-actions autorisé de la compagnie à 82,264,560.Daté du bureau du Procureur général, le 12 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27330 L.DESILETS.Velvasuede Lingerie Company, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 3 avril 1950, à la compagnie \"Velvasuede Lingerie Company, Limited\", ratifiant son Règlement \"D\" augmentant son capital-actions de 819,900 à 859,900, par la création de 400 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 3 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27330-o L.DÉSILETS.Ventes pour taxes \"Quebec Telephone Corporation\", ratifying: 1.its Special By-Law No.32: a) cancelling 13,714 unissued Class \"A\" Shares without nominal or par value; b) converting 36,286 issued Class \"A\" Shares without nominal or par value into 36,286 Class \"A\" Shares of the par value of SI5 each; c) converting the 50,000 Class \"B\" Shares without nominal or par value into 50,000 Commun Shares of the par value of 85 each; ° 17 Corporation municipale de Sainte-Anne des Monts \u2014 Municipal Corporation of Sainte-Anne des Monts Noma et prénoms Names and surnames\tNo Cad.Cad7~No.\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTaxes rel.Rel.taxes\tTota Pelletier, Simon & Héritiers légaux de feu Emile Pelletier Legal Heirs of lato Emile Pelletier.\tP.4.\tler-st.ler-st.ler-st.\tFief Ste-Anne Cap-Chat.\t11.03 32.30 61.59\t9.38 13.77 30.00\t\t21.31 246.57 465.59 \t25.\t\t\t\t\t199.50 374.00\t Lepage, Madame-Mrs.Emile\t30.\t\tCap-Chat.\t\t\t\t A distraire des bâtisses, la maison appartenant à To be deducted from the buildings, the house be-madame Robert Leclerc.longing to madame Robert Lcclerc.Corporation scolaire de Sainte-Anne des Monts Village\u2014 School Corporation of Sainte-Anne des Monts Village Lafontaine, Mme-Mrs.Adrien P.16-A.\tler-st.\tFief Ste-Anne\t33.70\t62.95\t15.60 112.15 \t\tdes Monts.\t\t\t) Etant un terrain de forme irrégulière, mesurant une Being a lot of land of irregular figure measuring a largeur do soixante-dix-neuf pieds et sept pouces à la width of seventy-nine feet and seven inches in the ligne Nord et do soixante-huit pieds (08') à la ligne North line and sixty-eight feet (68') in the South line Sud, sur uno profondeur moyenne de cent pieds (100'), by a mean depth of one hundred feet (100'), with avec bâtisses.buildings.Sergerio, Leopold.P.23-B & I P.23-C.ler-st.35.80 107.80 141.00 284.60 Fief Ste-Anne des Monts.Étant un terrain do forme irrégulière contenant Being a lot of land of irregular figure, containing an une superficie do vingt-et-un mille six cent dix-sept area of twenty-one thousand six hundred and seventeen pieds (21,617), avec maison dessus construite.feet (21.617), with house thereon erected.21.02 61.26 21.75 104.03 Lévesque, Mme-Mrs.Roméo.P.25-K.ler-st.Fief Ste-Anne I P.25-C.des Monts.Partie du lot 25-K est do forme irrégulière, ayant Part of lot 25-K, of irregular figure, having an area une superficie do cinq mille neuf cent dix-huit pieds of five thousand nine hundred and eighteen feet (5,918), avec bâtisses.(5,918), with buildings.Partie du lot 25-C est de forme irrégulière, ayant Part of lot 25-C, of irregular figure, having an area uno superDcio do trois mille cent quatre-vingt-dix of threo thousand one hundred and ninety feet (3,190), pieds (3,y)0), sans bâtisses.without buildings.Corporation municipale de Christie \u2014 Municipal Corporation of Christie Rioux, Leopold.I P.38.1 ler-st.I Christie.I 15.61 |.|.I 16.61 Etant un terrain do cent piods carrés, (100' x 100') Being a lot of land one hundred feet square (100' x avep bâtisse.100'), with buildings.Dion, René.I P.42.| ler-st.I Christie.I 24.66 I.|.| 24.60 Etant un t'errain de cent pieds carrés, (100' x 1000 Being a lot of land one hundred feet square (100' x avec bâtisse.100'), with buildings.Robinson, François.30.2me-nd.Blanchetto, Albert P.13-C.ler-st.& Joseph Boucher.Etant uno partie du lot 13-C, avec bâtisses, cir- Christie.Tourelle 13.65 4.40 \t 8.31\t \t 13.65 12.71 Being a part of lot 13-C, with buildings, circumstances constances et dépendances, bornée vers le Nord par and dependencies, bounded on the North by a road, une routo, vers 1 Est par lo lot 14-A, vers le Sud par on the east by lot 14-A, on the South by a part of lot partie du lot 13-C de Gérard Vallée et vers l'Ouest 13-C of Gérard Vallée and on the West by the land par le terrain occupé par Georges Boucher.occupied by Georges Boucher.Boucher.Georges.|.|.|.I 2.00 I 5.37 I.| 7.37 Maison et autres bâtisses, circonstances et dépen- House and other buildings, circumstances and dances construites sur partie du lot 13-C, 1er rang, dependencies built on part of lot 13-C, 1st range, canton Tourelle.Township Tourelle.Lévesque, Wilfrid (Jos.).| P.8.! ler-st.J Tourelle.I 8.89 | 35.28 I.| 44.17 Etant une terre d'une superficie de vingt-deux acres Being a farm of an area of twenty-two acres (22) (22) plus ou moins, avec les bâtisses dessus construites, more or less, with the buildings thereon erected, cir-circonstances et dépendances, bornée vers le Nord cumstances and dependencies, bounded on the North par le Chemin royal, vers l'Est par Wilfrid-Geo.Ser- by the King's Highway, on the East by Wilfrid-Geo.vant, vers le Sud et l'Ouest par Joseph-D.Lévesque.Servant, on the South and West by Joseph-D.Lévesque.St-Laurent, Orner & 5.12 25.73 30.85 P.9.ler-st.Tourelle Pierre-Paul.Etant une partie du lot 9 d'une superficie do vingt Being a part of lot 9 of an area of twenty acres, acres, avoc bâtisses, circonstances et dépendances, with buildings, circumstances and dependencies, bornéo vers le Nord par Joseph-Ant.Lévesque, vers bounded on the North by Joseph-Ant.Levesque, on l'Est par Louis-J.St-Laurent, vers le Sud par le petit the East by Louis-J.St-Laurent, on the South by the rang et vers l'Ouest par Josoph-D.Levesque.\"Petit\" range, and on the West by Joseph-D.Levesque Vallée, Wellie.I P.34.1 2.| Tourelle.| 17.29 | 11.72 I.| 28.01 D'une superficie de cinquante acres avec bâtisses, Of an area of fifty acres, with buildings, circumstances circonstances et dépendances, bornée vers le Nord and dependencies, bounded on the North by the first par le premier rang, vers l'Est par lo lot 35, vers le range, on the East by lot 35, on the South by the Sud par le troisième rang et vers l'Ouest par partie du third range and on tho West by part of lot 34 belonging lot 34 d'Emile Vallée.to Emile Vallée. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1241 Donné à Ste-Anne des Monts, ce quinze avril mil neuf cent cinquante.Le Secrétuirc-trésorier, LOUIS-PHILIPPE LANGELIER.27310-16-2-o Province de Québec, district de Chicoutimi Municipalité du Canton Bégin Avis est, par les présentes, donné que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du 11 avril 1950, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés, pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes ducs à la corporation municipale de Canton Bégin, avec intérêt et frais, et qu'en conséquence, les dits immeubles seront vendus par encan public, dans la salle du conseil de Canton Bégin, le 15 ième jour de MAI 1950, à 11 heures de l'avant-midi (heure avancée).Toutefois seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels toutes les taxes municipales de l'année 1949 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.1.Henri Maltais \"Charles\": Le lot 22, Rang 1.2.Henri Maltais \"Charles\": Le lot 27, Rang 1, sous réserve des droits de passage pour une ligne de transmission d'énergie électrique concédés à la Compagnie Electrique du Sagucnay, par acte enregistré le 18 novembre 1949 sous le numéro 97635.3.Felix Guay: Le lot 38, Rang 1.4.Thomas-Louis Gauthier: Les lots 39 et 40, Rang 1.5.François-Nil Villeneuve: Une ferme comprenant: a) Le lot 23, Rang 2, sous billet de location, b) Le lot 24, Rang 2, sous billet de location, avec réserve des droits de passage pour une ligne de transmission d'énergie électrique concédé à la Compagnie Electrique du Sagucnay par acte enregistré le 5 décembre 1949, sous le numéro 97,822.c) Le lot 25, Rang 2, sous billet de location, avec réserve des droits de passage pour une ligne de transmission d'énergie électrique concédés à la Compagnie Electrique du Sagucnay par acte enregistré le 5 décembre 1949, sous le numéro 97,822 sauf à distraire: un morceau de terrain de 700 pieds de largeur sur un acre de profondeur, le dit morceau de terrain étant borné comme suit: au nord et à l'est, par le résidu du dit lot; au sud, par le chemin public; à l'ouest, par le lot 26, Rang 2, appartenant à Joseph St-Hilaire.6.Hilaire Gagnon : Le lot 34, Rang 2, sous billet de location.7.Patrick Lapointe: Partie du lot 33-A, Rang 4, borné comme suit: au nord, à la partie du même lot appartenant à Napoléon Lévesque; à l'est, au lot 32, Rang 4; au sud, à la partie du lot 33-A, Rang 4, appartenant à P.-E.Pearson; à l'ouest, au chemin public.8.Philias Savard: Le lot 42, Rang 6.Tous les lots et parties de lots ci-dessus sont connus et désignés aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du Canton Bégin et seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y a lieu, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes attachées aux dits immeubles.Le prix de l'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Given at Ste-Anne des Monts, this fifteenth day of April, one thousand nine hundred and fifty.LOUIS-PHILIPPE LANGELIER, Secretary-Treasurer.27310-16-2 Province of Quebec, district of Chicoutimi Municipality of the Township of Begin Notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the 11th of April, 1950, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1941, chapter 207), to sell the immovables herein-below described, in payment of arrears of taxes due the municipal corporation of the Township of vBégin, with interest and costs, and that consequently, the said immovables will be sold by public auction, in the council hall of the Township of Begin, on the FIFTEENTH day of MAY, 1950, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).However, there shall be excluded from the sale, those immovables whereon all municipal taxes for the year 1949 and previous years, shall have been paid before the sale.1.Henri Maltais \"Charles\": Lot 22, Range 1.2.Henri Maltais \"Charles\": Lot 27, Range 1, under reserve of rights of way for an electric power transmission line conceded to the \"Compagnie Electrique du Sagucnay\" by deed registered on the 18th of November, 1949, under No.97,635.3.Felix Guay: Lot 38, Range 1.4.Thomas Louis Gauthier: Lots 38 and 40, Range, 1.5.François Nil Villeneuve: A farm comprising: a) Lot 23, Range 2, under location ticket.b) Lot 24, range 2, under location ticket, with reserve of rights of way for an electric power transmission line conceded to the \"Compagnie Electrique du Saguenay\" by deed registered on the 5th of December, 1949, under No.97822.c) Lot 25, Range 2, under location ticket, with reserve of rights of way for an electric power transmission line conceded to the \"Compagnie Electrique du Saguenay\" by deed registered on the 5th of December, 1949, under No.97822, save to be deducted: a parcel of land 700 feet wide by one acre in depth, the said parcel of land being bounded as follows: on the north and east, by the residue of said lot; on the south, by the public road; on the west, by lot 26, Range 2, belonging to Joseph St-Hilaire.6.Hilaire Gagnon: Lot 34, Range 2, under location ticket.7.Patrick Lapointe: Part of lot 33-A, Range 4, bounded as follows: on the north, by the part of the same lot belonging to Napoléon Levesque; on the cast, by lot 32, Range 4; on the south, by the part of lot 33-A, Range 4, belonging to P.E.Pearson; on the west by the public road.8.Philias Savard: Lot 42, Range 6.All the lots and parts of lots above described are known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the Township of Begin and will be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any, and with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immovables.The purchase price of each of the said immovables will be payable immediately. 1242 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril I960, Tome 82, N° 17 La vente sera en outre sujette aux droits de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Canton Bégin, ce 14ième jour du mois d'avril 1950.Le Secrétaire-Trésorier, 272S9-lG-2-o ROMÉO LEVESQUE.The sale shall, moreover, be subject to right of redemption and to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at the Township of Begin, this 14th day of the month of April, 1950.ROMÉO LEVESQUE, 27289-16-2 Secretary-Treasurer.Province de Québec Municipalité du Comté de Mégantic Avis public est par le présent donné par Edouard Houde, secrétaire-trésorier que les terrains ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique, dans le village d'Inverness, au lieu où le conseil du comté de Mégantic tient ses sessions, MERCREDI, le QUATORZIEME jour de JUIN 1950, à DIX heures du matin, â défaut du paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et les frais encourus.Province of Quebec Municipality of the County of Meoantic Public notice is hereby given by Edouard Houde, secretary-treasurer, that the under-men-tionncd lands will be sold at public auction, in the village of Inverness, at the place where the county council holds its sittings, on the WEDNESDAY, the FOURTEENTH day of JUNE 1950 at TEN o'clock in the forenoon, in default of payment of the taxes due thereon and costs incurred.Municipalités Municipalities\tCantons Townships\tPropriétaires Proprietors\tLots \u2022\tTaxos \tInverness.\tGeorge E.Davidson.Mai 1 lias Gilbort.\tH N.E.303-304 P-705\t \tInverness.\t\t\t$177.00 $108.80 \t\t\t\t Municipalité de St-P.-Baptiste Municipality of St-Pierre-Baptiste Un terrain situé sur le 4ième rang du canton d'Inverness, contenant 107 Acres, plus ou moins, connu au cadastre officiel du Canton d'Inverness comme étant la l/2 nord-ouest no: 248 borné en front au sud-ouest par le chemin public entre les rangs 3 et 4, en arrière au nord-est par la ligne de division entre les rangs 4 et 5, d'un côté au nord-ouest par le lot no: 250, et de l'autre côté au sud-est par la moitié sud-est du lot no: 248 appartenant à Léo Paradis, avec les bâtisses dessus.Connu comme appartenant à Donald MacMillan.Montant dû: 814.25.A lot situated on the 4th range of the Township of Inverness, containing 107 acres, more or less, known at the reference book for the Township of Inverness, as the % north-west of no: 248, bounded in front at the south-west by the public road between ranges 3 and 4, in the back at the north-east by the division line between ranges 4 et 5, on one side at the north-west by lot no: 250 and on the other side at the south-east by the south-east half of lot no: 248, owned by Léo Paradis, with buildings.Known as belonging to Donald MacMillan.Amount due: 814.25.Municipalité de Leeds canton Municipality of the Township of Leeds 200 acres de terre, lots nos: 6-B et 7-A du rang 5 du livre de renvoi du canton de Leeds, connu comme appartenant à Georges Donaghy, Thetford-Mines.Montant dû: 22.95.Plessisville, le 18 avril 1950.Le Secrétaire-trésorier, Corp.Cté Mégantic, 27303-16-2-o EDOUARD HOUDE.200 acres of land, lots no: 6-B and 7-A, range 5, of the cadastre survey of the Township of Leeds, county of Mégantic.Known to belong to George Donaghy, Thetford-Mines, P.Q.Amount due: 822.95.Plessisville, April 18th 1950.EDOUARD HOUDE, Secretary-Treasurer 27303-16-2-o of Corp.Co.Meg.Province de Québec Comté du Lac St-Jean Municipalité scolaire de la ville de St-Joseph D'Alma Avis Public est, par les présentes donné, que la Commission Municipale de Québec, par un arrêté en date du 14 avril 1950, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission Municipale de Québec (SQR, 1941, chapitre 207), de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des taxes dues à la municipalité scolaire de la ville de St.Joseph d'Alma, avec inté-térêt et frais, et qu'en conséquence, les dits im- Province of Quebec County of Lake St.John School Municipality of the Town of St.Joseph D'Alma Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the 14th of April, 1950, has ordered the undersigned,\" pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1941, chapter 207), to sell the immovables herein-below described in payment of taxes due the school municipality of the Town of St.Joseph d'Alma, with interest and costs, and that consequently the said immovables will be sold by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1243 meubles seront vendus par encan public, dans la salle du conseil, à l'Hotcl-de-ville à St-Joseph d'Alma, le 15 JUIN 1950, ù 10 heures de l'avant-midi.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels toutes les taxes scolaires échues auront été payées avant le moment de la vente.1 \u2014 Wellie Bergeron.Le lot n° 4-70, étant une subdivision du lot n° 4, des plans et livre do renvoi officiels du cadastre pour le rang 1, de l'Ile d'Alma, canton Delisle, avec toutes les constructions y érigées, circonstances et dépendances, et borné comme suit: vers le nord-ouest par le lot n° 4-75 des dits rangs et canton, vers le sud-est par le lot n\" 4-70; vers le sud-ouest par le lot 4-77; vers le nord-ouest par le lot n° 4-74; ayant 50 pds on front sur 100 pds do profondeur et contenant on superficie cinq mille pieds MA.Sur le lot n° 4-77, lo nom do Wellie Bergeron n'apparait pas de même que celui du Prêt Hypothécaire.2 \u2014 Placide Collard.Un terrain faisant partie du lot n° 1-264 de l'Ile n° 1, lettre G des Iles do la Petite Décharge du canton Delisle, mesurant 50 pds de l'ouest à l'est et 50 pds du nord au sud et borné: au nord au terrain des représentants de Victor Côté; au sud au terrain do Mtre J.-Aimé Fortin; à l'est au terrain des représentants de Clarcy Gaudreault, épouse d'Adélard Dufour, et à l'ouest à une rue portant le n° 1-203.i 3 \u2014 Placido Collard.Un autre emplacement mesurant environ 115 pds dans la ligne ouest et environ 75 pds dans la ligne est sur environ 50 pds de l'ouest a l'est, faisant partie du lot n° 1-265 de l'Ile n° 1, lettre G des Iles de la Petite Décharge, du canton Delisle, lequel terrain est borné: au nord au reste du lot dont il fait partie et appartenant lors do l'achat à Yvette Gagné; au sud à la Petite Décharge, mais sans affecter lo terrain ou les droits de Québec Dcveloppment Company Ltd; à l'ouest au lot n° 1-264 dont une partie appartient au vendeur; à l'est au lot n° 1-266; l'intention des parties étant que la borne nord du terrain présentement vondu soit déterminée par la continuation vers l'est, dans sa direction actuelle, do la borno nord du terrain ci-dessus décrit au paragraphe 1.4 \u2014 Laurent Boivin.Le lot n° 13-a-6, rang 9, canton Signal.5 \u2014 Laurent Boivin.Le lot n° 13-a-7, rang 9, canton Signal.6 \u2014 Dame J.Charles Côté.Une partie du lot n° 16-22 du rang 9 canton Signal, qui mesure 80 pds do longueur sur toute la largeur de ce lot et borné: au nord au reste du lot dont elle fait partie; au sud au reste du lot dont elle fait partie; au sud à une rue portant lo n° 1 du Parc Central, à l'ouest au lot n° 16-23, à l'est au lot n° 16-21, et au nord au reste du lot dont elle fait partie et appartenant à la venderesse.7 \u2014 Dame J.-Charles Côté.Une lisière do terrain faisant partie du lot n° 16-21 du rang 9, canton Signal mesurant 10 pieds de largeur ou de l'ouest h l'est sur 80 pds de profondeur ou du sud au nord et bornée: au sud à la rue no 1, du Parc Central; au nord au reste du lot dont elle fait partie et demeurant a la venderesse; a l'ouest au lot n° 16-22 et a l'est au reste du lot dont elle fait partie.Mme Philippe Girard se réserve à perpétuité sur la dite partie du dit lot 16-22 vendue, un droit de passage à pieds et en voiture de 10 pds de largeur, à prendre dans toute la longueur de cette partie vendue par les présentes mais immédiatement lo long du lot n° 16-23 des dits rang et canton, pour l'utilité de la lisière do 20 pds des dits lots 16-21 et 16-22 et 16-10 des dits rangs et canton comme \"Fonds dominant\".8 \u2014 Dame Ernest Côté.Un terrain situé en la Ville de St-Joseph D'Alma, mesurant environ 45 pds au sud, 43^ Pds au nord, et 160 pds do profondeur ou du sud au nord étant et comprenant la juste demie-ouest du lot n° 3-B-17 du rang 1 do l'Ile d'Alma du canton Delisle, laquelle demie-ouest est ainsi bornée: au sud au lot n° 3-B-16 (rue Sauvé); au nord au lot n° 3-B-18; à l'ouest au lot n° 3-B-18 et 3-B19, à l'est à la juste-demie est du lot dont elle fait partie.9 \u2014 Lucien Collard.Un terrain faisant partie du lot n° 16 du rang 9 canton Signal, borné à l'ouest au lot 17B, à l'est au ruisseau rouge en front de la Petite Décharge, et en arrière partie au chemin public et partie au terrain de la Compagnie du Chemin do fer, Aima et Jonquière.10 \u2014 Ludger Fortin.Lo lot 3-B-38 rang 1, Ile d'Alma, canton Delisle, et sujet cependant au droit de public auction, in the council hall, in the Town Hall of St.Joseph d'Alma, on the FIFTEENTH day of JUNE, 1950, at TEN o'clock in the forenoon.However, there shall be excluded from the sale those immovables whereon all the school taxes due shall have been paid before the sale.1.Wellie Bergeron \u2014 Lot No.4-76, being a subdivision of lot No.4, of the official cadastral plan and in the book of reference for range 1, of lie d'Alma, township Delisle, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and bounded as follows: towards the northwest by lo No.4-75 of said range and township, towards the southeast by lot No.4-70; towards the south-west by lot 4-77; towards the northwest by lot N.4-74; measuring 50 feet in front by 100 feet in depth and containing a superficial area of five thousand feet E.M.On lot No.4-47 the namo of Wellie Bergeron and that of the \"Prêt Hypothécaire\" do not appear.2.Placide Collard \u2014 A lot of land forming part of lot No.1-264 of Island No.1, letter G of the Islands of the \"Petite Décharge\" of the township Delisle, measuring 50 feet from west to east and 50 feet from north to South and bounded: \u2014 on the north by the land of the representatives of Victor Côté: on the south by the land of Mtre J.Aimé Fortin; on the east by the land of the representatives of Clarcy Gaudreault, wife of Adélard Dufour, and on the west by a street bearing No.1-263.3.Placide Collard \u2014 Another emplacement measuring about 115 feet in the west lino and about 75 feet in the oast line by about 50 feet from west to east, forming part of lot No 1-265 of the Island No.1, letter G, of the Islands of the \"Petite Décharge\", of the township Delisle, the said lot of land being bounded: on the north by the residue of the lot of which it forms a part and belonging, at the time of the purchase: to Yvette Gagné; on the south by the \"Petite Décharge\" but without affecting the land or the rights of the Quebec Development Company Ltd; on the west by lot No.1-264 of which a part belongs to the vendor; on the east by lot No.1-266; the intention of the parties being that the north boundary of the land presently sold be determined by the continuation eastward, in its actual direction, of the north boundary of the lot of land above described in paragraph 1.4.Laurent Boivin: Lot No.13-a-6, range 9, township Signal.5.Laurent Boivin \u2014 Lot No.13-a-7, range 9, township Signal.6.Dame J.Charles Côté \u2014 A part of lot No.16-22 of range 9, township Signal, which measures 80 feet in length by the whole width of the said lot and bounded: on the north by the residue of the lot of which it forms a part; on the south by the residue of the lot of which it forms a part; on the south by a street bearing No.1 \"Pare Central\", on the west by lot No.16-23, on the east by lot No.16-21, and on the north by the residue of the lot of which it forms a part and belonging to the vendor.7.Dame J.Charles Côté \u2014 A strip of land forming part of lot No.16-21 of range 9.township Signal, measuring 10 feet in width or from west to east by 80 feet in depth or from south to north, and bounded: on the south by the street No.1 \"Pare Central\"; on the north by the residue of the lot of which it forms a part and remaining to the vendor; on the west by lot No.16-22 and on the east by the residue of the lot of which it forms a part.Madame Philippe Girard reserves, in perpetuity, over the said part of said lot 16-22 sold, a right of way on foot and with vehicle measuring 10 feet in width, to be taken'on the full length of the said part hereby sold but immediately along lot No.16-23 of said range and township, for the use of the strip of 20 feet of said lots 16-21 and 16-22 and 16-10 of said range and township as \"Dominant Land\".8.Dame Ernest Côté \u2014 A lot cf land situate in the Town of St-Joseph d'Alma, measuring about 45 feet on the south, 43>£ feet on the north, and 160 feet in depth or from south to north, being and comprising the exact west half of lot No.3-B-17 of range 1 of He d'Alma of the township Delisle, the said west half being bounded as follows: on the south by lot 3-B-16 (Sauvé street); on the north by lot No.3-B-18; on the west by lot No.3-B-18 and 3-B-19, on the east by the exact east half of tho lot of which it forms a part.9.Lucien Collard \u2014 A lot of land forming part of No.16 of range 9 township Signal, bounded on the west by lot 17-B, on the east by the \"Ruisseau Rouge\" in front of the \"Petite Décharge\", and in rear partly by the public road and partly by the land of tho Alma and Jonquière Railway Company.10.Ludger Fortin \u2014 Lot 3-B-38 range 1, He d'Alma, township Delisle, and subject, however, to right of 1244 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 vue en favour do Roméo Côté propriétaire du terrain ci-après distrait.Du lot 3-B-38 il faut distraire le terrain vendu par Ludger Fortin à Roméo Côté par acte devant J.-A.Gingras N.P.lo 12 décembre 1930, enregistré lo 16 décembre 1930 sous lo n° 34449.11.Lauréat Gagné.Lo lot n° 4-8 du rang 1, Ile d'Alma, canton Delisle, étant une subdivision de partie du lot 4.Lauréat Gagné n'a que la jouissance et l'usufruit do cet immeuble, tandis quo la nue propriété appartient au Rév.Père Lucien Gagné.13 \u2014 Georges-Henri Gauthier.Un terrain mesurant 50 pds du nord au sud, il partir de la ligne de division des lots 14a92 et I4a93 et environ 80 pds de l'est h l'ouest, lequel terrain fait partie du lot n° 14a92 rang 0 canton Signal, lequel terrain est borné comme suit: au nord au lot n° 14a93, a l'est à uno rue portant lo no 14a81 (ave St.Pierre) et à l'ouest au lot n° 15A.14 \u2014 Alcide Gagnon.Un terrain faisant partie du lot 17A rang 9 canton Signal, de forme triangulaire, mesurant environ 130 pds ft l'ouest et environ 240 pds au nord ou vers lo nord, et à peu près 160 pds du sud, lequel terrain est borné au nord ou vers lo nord au terrain de la Cie du Chemin do for Aima et Jonquière, au sud au chemin de front du dit rang, à l'ouest à une ligne droite imaginaire passant d'un point au chemin do front du dit rang lequel point est distant de 05 pids do la ligne do séparation des lots 17-A et 18-A des dits rang et canton, et courant vers le nord pour jusqu'au terrain de la Cie de chemin de fer Aima et Jonquière, et à un point distant d'environ 70 pieds de la ligne de séparation précitée, mais sous la réserve d'une établo appartenant à Georges Lebel.sauf h distraire: a) le terrain vendu par Alcide Gagnon à Gonzague d'Amours par acte enregistré sous le n° 37803; b) un petit terrain vendu ;\\ Raoul Larouche par acte enregistré sous lo n° 36134.15\u2014Victorien Gagnon.Le lot n° P-4-10, rang 1, Ile d'Alma canton Delislo.16 \u2014 Victorien Gagnon.Le lot n° P-4-11, rang 1, Ile d'Alma, canton Delisle.17 \u2014 Stanislas Gaudreault.Le lot n° 15-a-24, rang 0, canton Signai, qui apparait au nom du Prêt Hypothécaire de Québec.18 \u2014Ferdinand Gauthier.Le lot n° 13-A-98 du rang 9, canton Signal.19\u2014Ferdinand Gauthier.Le lot n° 13-a-99, du rung 9, canton Signal.20 Rosaire Hébert.Le lot n° 13-A-88 rang 9, canton Signal.21 \u2014 Jean-Bte Girard.Un terrain étant et comprenant la juste domie-est du lot n° 14a21, rang 9, canton Signal, mesurant 50 pieds de front sur 100 pds de profondeur plus ou moins, ot borné: au nord à la rue Collard; au sud ad lot n° 14a25; à l'ouest à juste domie-ouest du lot dont elle fait partie et a l'est au lot n° 14a22.22\u2014Dame Henri Jean.Le lot n° 4-66, rang 1, Ile d'Alma, du canton Delisle.23\u2014Donat Labonté.Le lot n° 4-18, rang 1, Ilo d'Alma, Delisle.24\u2014 Joseph Lalancette.Le lot 12-40, rang 9, canton Signal.25 \u2014 Joseph Lalancette.Le lot 12-41, rang 9, canton Signal.26 \u2014 Nil Lapointe.Le lot n° 1-267, des Iles de la Petite Décharge canton Delisle.27 \u2014 Albéa Maltais.Un terrain mesurant 50 pds do front dans le sens do la ruo et 100 pds de profondeur faisant partie du lot n° 14a59, étant une subdivision du lot 14A, rang 9, canton Signal, borné au nord à la ruo 14a-52, à l'est au lot 14a60, au sud à une partie du lot 14a64, a l'ouest à l'autre moitié du dit lot n° 14a59.28 \u2014 Dame Joseph Morin.Lè lot n° 1A82, rang Saguenay, canton Labarre.29 \u2014 Joseph Paquet.Un terrain faisant partie du lot 17A, rang 9, canton Signal, mesurant 50 pds do largeur ou de l'est à l'ouest sur la profondeur qu'il y a à partir du chemin public, (rue St.Joseph), au sud à la tête de la Petite Décharge (à la plus haute eau), et borné au sud au chemin public, (rue St.Joseph) à l'est au terrain do Louis Turgeon, à l'ouest partie à une rue portant le N° 17al22, et partie au lot 17al23, et au nord a la Petite Décharge a la plus haute eau.30 \u2014 Henri Potvin.Un terrain faisant partie du lot 16, canton Signal, rang 9, de forme triangulaire, mesurant environ 125 pds à l'ouest et environ 80 pds au nord borné au nord au chemin do front ruo St.Joseph) à l'ouest au lotl7B, au sud et au sud-est au ruisseau rouge.31 \u2014 Joseph Roy.Le lot n° 16-4, rang 9, canton Signal, sauf à distraire cotte lisière vendue par Joseph Roy à la Ville do St.Joseph d'Alma par acte enregistré le 14 janvier 1941, sous lo n° 37954.view in favour of Roméo Côté ownor of tho land hereinafter deducted.From lot 3-B-38 there is deducted tho land sold by Ludger Fortin to Roméo Côté by deed before J.A.Gingras, N.P., on tho 12th of December, 1936, registered the 16th of December, 1936, under No.34449.11.Lauréat Gagné \u2014 Lot No.4-8 of range 1, He d'Alma, township Delislo, being a subdivision of a part of lot 4.Lauréat Gagné has but the enjoyment and usufruct of the said immovable, while the bare ownership belongs to tho Rev.Father Lucien Gagné.13.Georges Henri Gauthier \u2014 A lot of land measuring 60 feet from north to south, starting at the division line of lots 14-a-92 and 14-a-93 and about 80 feet from east to west, the said lot of land forms part of lot No.14-a-92 range 9, Township Signal, tho said lot of land is bounded as follows: on the north by lot 14-a-93, on tho oast by a street bearing No.14-a-81 (ave St.Pierre) and on the west by lot No.15A.14.Alcide Gagnon \u2014 A lot of land forming part of lot 17A range 9, township Signal, of triangular figure, measuring about 130 feet on the west and about 240 feet on the north or towards tho north, and about 160 feet on tho south, tho said lot of land is bounded on tho north or towards tho north by the land of tho Alma and Jonquière Railway Company, on tho south by tho front road of said range, on tho west by an imaginary straight line passing from a point on the front road of said range tho said point being 65 feet distant from the division lino of lots 17-A and 18-A of said range and township, and running northward as far as the land of the Alma and Jonquière Railway Compuny, and at a point 70 feet distant from the division line above cited, but under tho reserve of a stable belonging to Georges Lebel, save and to bo deducted: a) the land sold by Alcide Gagnon to Gonzague d'Amours by deed registered under No.37803; b) a small lot of land sold to Raoul Laroche by deed registered under No.36134.15.Victorien Gagnon \u2014 Lot No.P-4-10, range 1, He d'Alma, township Delisle.16.Victorien Gagnon\u2014Lot No.P.-4-11, range 1, Ilo d'Alma, township Delisle.17.Stanislas Gaudreault \u2014 Lot No.15-a-24, range 9, township Signal, which appears in the name of the \"Prêt Hypothécaire de Québec\".18.Ferdinand Gauthier\u2014 Lot No.13-A-98 of range 9, township Signal.19.Ferdinand Gauthier \u2014 Lot No.13-A-99, of range 9, township Signal.20.Rosaire Hébert\u2014Lot No.13-A-88, rango 9, township Signal.21.Jean Bte.Girard \u2014 A lot of land being and comprising the exact cast half of lot No.14-A-21, range 9, township Signal, measuring 50 feet in front by 100 feet in depth, more or less, and bounded: \u2014 on the north by Collard street; on the south by lot No.14-a-25; on tho west by the exact west half of the lot of which it forms a part and on tho east by lot No.14-A-22.22.Dame Henri Jean \u2014Lot No.4-66, rango 1, He d'Alma, township Delisle.23.Donat Labonté\u2014Lot No.4-18, range 1, lie d'Alma, Delisle.24.Joseph Lalancette \u2014 Lot 12-40, range 9, township Signal.25.Joseph Lalancette \u2014 Lot 12-41, range 9, township Signai.26.Nil Lapointe \u2014 Lot No.1-267, of tho Islands of the \"Petite Décharge, township Delisle.27.Albéa Maltais.\u2014 A lot of land measuring 50 feet in front in tho direction of the street and 100 feet in depth, forming part of lot No.14-A-59, being a subdivision of lot 14-A, rango 9, township Signal bounded on tho north by the street 14-a-52, on the east by lot 14-a-60, on the south by a part of lot 14-a-64, on tho west by the other half of said lot No.14-a-59.28.Dame Joseph Morin \u2014 Lot No.l-A-82, Saguenay range, township Labarre.29.Joseph Paquet \u2014 A lot of land forming part of lot 17A, range 9, township Signal, measuring 50 feet in width or from east to west, by whatever depth there may be between the public road (St.Joseph street), on the south and the head of the \"Petite Décharge\" (at highest water), and bounded on the south by the public road, (St.Joseph street), on the east by the land of Louis Turgeon, on tho west partly by a street bearing No.17-a-122, and partly by lot 17-a:123, and on the north by tho \"Petite Décharge\" at high water.30.Henri Potvin \u2014 A lot of land forming part of lot 16, township Signal, range 9, of triangular figure, measuring about 125 feet on the west and about 80 feet on the north, bounded on the north by tho front road (St.Joseph street), on the west by lot 17-B, on tho south and southeast by tho \"Ruisseau Rouge\".31.Joseph Roy \u2014 Lot No.16-4, range 9, township Signal, save to bo deducted the strip of land sold by Joseph Roy to the Town of St.Joseph d'Alma, by deed registered on the 14th of January, 1941, under No.37-954. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1960, Vol 82, No.17 1245 32 \u2014 Pierro-Émilo Garon.Un terrain mesurant 45 pds de largeur plus ou moins sur la rue St.Joseph, 35 pds de largeur au bout do profondeur sur environ 190 pds de profondeur, faisant partie du lot n° P4, rang 1, Ile d'Alma, canton Delisle ot borné comme suit: en front a la route régionale ou plus précisément ft la rue St.Joseph, en arrière ou ft l'ouest au terrain d'Elio Gagné ou représentants du côté Nord, au représentant d'Agénor Lapointe, et au sud aux représentants de Joseph Côté; sauf ft distraire une partie mesurant 10 pds de largeur sur une profondeur do 22 pds avec une grange y érigée lequel terrain et bâtiment appartiennent à Philippe Lavoie représentant do Dame Vve Thomas Harvey.33 \u2014 Jean-Arthur Simard.Un terrain mesurant 90 pds de largeur dans le sens du chemin public et 147 pds de profondeur faisant partie du lot 1-A du rang Saguenay, canton Labarre, borné à l'ouest à Philippe Truchon, à l'est au lot 2-A, au sud au chemin public.37 \u2014 Emery Tremblay.Lo lot no 13alG0, rang 9, canton Signal.38 \u2014 Emory Tremblay.Le lot n° 13al61, rang 9, canton Signal.39 \u2014 Thomas Tremblay William.Un terrain mesurant environ 100 pds de profondeur ou du nord au sud sur 50 pds de largeur ou de l'ouest â l'est, faisant partie du lot n° 14a60 étant la juste demie-ouest de cet immeuble, du rang 9, canton Signal, borné au nord à la rue Scott, 14a52, au sud nu lot n° 14aG3, â l'ouest au lot 14a59, et a l'est ft la juste-demie-est du lot dont il fait partie.40 \u2014 Philippe Tremblay, cult.Lo lot n° 4-55, rang 1, Ile d'Alma, canton Delisle, qui apparaît au nom de Dame Philippe Tremblay.41 \u2014 René Tremblay.Le lot 13al34, rang 9, canton Signal.Ce lot apparaît la propriété du Prêt Hypothécaire, qui l'a acquis do Fernando Tremblay, qui lui-même l'avait acquis de Dame J.Collard.42 \u2014 Adolphe Verreault.Cet emplacement ci-après décrit appartient à Adolphe Verreault et à Dame Marie-Lise Odile Therrien, Veuve de Charles Verreault, sa mère chacun pour une moitié indivise: Un terrain avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, en forme de quadrilatère, situé en la villo de St.Joseph d'Alma, ruo Labrecque, mesurant vers lo Nord-Ouest, dans le sens de la rue, soixante-et-cinq (05) pieds, et côté opposé vers lo Sud-Est, soixante-ct-cinq (rc) pieds; vers le Nord-Est environ cent un (101) pieds, et vers le sud-Ouest environ cent trois pieds (103) borné vers le nord-Ouest au lot numéro treize-A-trente sept (13-A-37), ruo Labrecque, vers le nord Est, aux terrains d'Anicet Bouchard et de Charles Maltais, vers le Sud-Est au terrain d'Elzéar Harvey ou représentants, vers le Sud-Ouest au terrain de Charles Maltais; le dit terrain faisant partie du lot numéro treize-A (13-A) du rang neuf, du cadastre officiel du canton Signal, comté Lac St-Jean, et du lot numéro treize-A-quarante-scpt (13-A-47) des mêmes rang et canton , la partie 13A mesurant à la ligne Nord-ouest environ 49 pds et étant borné au Sud-Ouest au lot treizo-A-quarante-sept (13-A-47), et la partie de trejze-A-quarante-sept étant bornée au Nord-Est au lot treize-A et mesurant à la ligne Nord-Ouest, environ quinze pieds et demi; avec les servitudes actives et passives, apparantes et ocultes, à.la réserve d'un chemin de cinq (5) pieds do largeur sur le terrain ci-dessus, & prendre le long de la ligne Sud-Ouest pour faire avec cinq autres pieds à prendre sur lo terrain de Charles Maltais un chemin mitoyen.43 \u2014 Dame Robert Willcocks.Le lot n° 18a47, rang 9, canton Signai.44 \u2014Dame Robert Willcocks.Le lot n° 18a48, rang 9, canton Signal.> 45 \u2014 Gérard Bouchard.Un terrain faisant partie du lot 4-74, étant une subdivision du lot n° 4, rang 1, Ile d'Alma, canton Delisle mesurant 60 pds de largeur comptés le long des lot 4-67 et 4-66 sur toute la profondeur comptée ft partir des susdits lots jusqu'à la petite Décharge, borné vers le nord au lot 4-67, et uno partie du lot 4-66, vers l'est aux lots 4-75 et 4-76 et 4-77, vers le sud ft la petite Décharge, vers l'ouest au reste du lot 4-74, avec les servitudes actives ot passives, notamment la servitude de passage résultant de l'acte n° 37748, et à distraire les droits do Price Brothers Co.Ltd, ainsi que ceux de B.A.Scott ou représentants.46 \u2014 Charles Tremblay.Le lot pl4al0, rang 9, canton Signal.Tous ces immeubles seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y en a, et avec toutes servitudes actives et passives, apparentes et occultes, pou- 32.Pierre Emile Garon \u2014 A lot of land measuring 45 feet in width more or less on St.Joseph street, 35 feet in width at the end of the depth by about 190 feet in depth, forming part of lot P-4, rango 1, Ilo d'Alma, township Delisle, and bounded as follows: in front by tho regional highway or more precisely S.Joseph street, in rear on the west by the land of Elle Gagné or representatives, on tho north side, by tho representative of Agenor Lapointe, and on tho south by the representatives of Joseph Côté; save to be deducted a part measuring 10 feet in width by a depth of 22 feet \u2014 with a barn thereon erected, the said lot of land and building belong to Philippe Lavoie, representative of Dame Wid.Thomas Harvey.33.Jean Arthur Simard.\u2014 A lot of land measuring 90 feet in width in the direction of the public road, and 147 feet in depth, forming part of lot 1-A of the Saguenay rango, township Labarrc, bounded on tho west by Philippe Truchon, on the east by lot 2-A, on the south by the public road.37.Emery Tremblay \u2014 Lot No.13-a-160, range 9, township Signal.38.Emery Tremblay \u2014 Lot No.13-a-161, range 9, township Signal.39.Thomas Tremblay William \u2014 A lot of land measuring about 100 feet in depth or from north to south, by 50 feet in width or from west to east, forming part of lot No.14-a-60, being the exact west half of the said mmovable, of range 9, township Signal, bounded on the north by Scott street, 14-a-52, on the south by lot No.14-a-63, on the west by lot 14-a-59, and on the east by the exact east half of the lot of which it forms a part.40.Philippe Tremblay, farmer.\u2014 Lot No.4-55, range 1, He d'Alma, township Delisle, which appears under the name of Dame Philippe Tremblay.41.René Tremblay\u2014Lot 13-a-134, range 9, township Signal.This lot appears to be tho property of the \"Prêt Hypothécaire\", who acquired it from Fernando Tremblay, who in turn acquired it from Dame J.Collard.42.Adolphe Verreault \u2014 Tho said emplacement hereinafter described belongs to Adolphe Verreault and to Dame Marie Lise Odile Therrien, widow of Charles Verreault, his mother, an undivided half for each: A lot of land with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, of quadrilateral figure, situate in the Town of St.Joseph d'Alma, Labrecque street, measuring on tho northwest, in the direction of the street, sixty-five (65) feet, and on the opposite side towards the southeast, sixty-five (65) feot; on the northeast about one hundred and one (101) feet, and on the southwest about one hundred and three feot (103), bounded on the northwest by lot number thirteen-A-thirty-seven (13-A-37), Labrecque street, on the northeast- by the lots of land belonging to Anicet Bouchard and Charles Maltais, on the southeast by the land of Elzéar Harvey or representatives, on the southwest by the land of Charles Maltais; the said lot of land forms part of lot number thirteen-A (13-A) of rango nine, of the official cadastre for tho township Signal, county of Lake St.John, and of lot number thirteen-A-forty-seven (13-A-47) of tho same range and township; the part 13-A measuring in the northwest line about 49J4 feet and being bounded on the southwest by lot thirteen-A-forty-seven (13-A-47), and the part of thirteen-A-forty-seven being bounded on the northeast by lot thirteen-A and measuring in tho northwest line, about fifteen and one half feet; with the active and passive, apparent and unapparent servitudes, with tho reserve of a road five (5) feet wide over tho land above described, to be taken a long the southwest line to make, with five other feet to be taken on the land of Charles Maltais, a \"mitoyen\" road.43.Dame Robert Willcocks \u2014 Lot No.18-a-47, range 9, township Signal.44.Dame Robert Willcocks \u2014 Lot No 18-a-48, range 9, township Signal.45.Gérard Bouchard \u2014 A lot of laud forming part of lot 4-74, being a subdivision of lot No.4, range 1, lie d'Alma, township Delisle, measuring 60 feet in width measured along lots 4-67 and 4-66, by the whole depth measured from the aforesaid lots as far as the \"Petite Décharge\", bounded on the north by lot 4-67, and a part of lot 4-66, on the east by lots 4-75 and 4-76 and 4-77, on the south by the \"Petite Décharge\", on the west by tho residue of lot 4-74, with the active and passive servitudes, in particular the servitude of passage resulting from the deed No.37738, and to be deducted the rights of Price Brothers Co.Ltd.and also those of B.A.Scott or representatives.46.Charles Tremblay \u2014 Lot P-14-a-10, range 9, Township Signal.All these immovables will be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any, and with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes affect- 1246 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 vaut les affecter et sujets principalement aux droits de baignage et servitudes appartenant à Sagucnay Power Co.ou représentants.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission Municipale de Québec.Donné à St.Joseph d'Alma, ce 12ième jour d'avril 1950.Le Secrétaire-trésorier, 27350-17-2-o J.-L.-ROMEO JOBIN.Province de Québec, District de Chicoutimi Municipalité du village de Saint-Alexis de la Grande-Baie Avis public est, par les présentes donné, que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du vingt avril 1950.a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes ducs à la corporation du village de Saint-Alexis de la Grande-Baie, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du conseil, à l'hôtel de ville de Saint-Alexis-dc-la-Grande-Baic.le VINGT-SIX MAI 1950.à ONZE heures de l'avant-midi (heure avancée).Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels toutes les taxes municipales de l'année 1949 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.1.Louis-Joseph Dufour: a) Un terrain formant partie du lot 79 mesurant en front 36 pieds sur environ 170 pieds de profondeur, borné et compris dans les limites suivantes: lin front, a la rue Si-a ml ré; en arrière, au terrain d'Edmond Savard; d'un côté, au nord, par le terrain do David Lavoic ou représentants; et de l'autre côté, au sud, partie au terrain en deuxième lieu décrit et appartenant autrefois à Joseph Tremblay, et sur lequel terrain du dit Edmond Savard et autres, ledit Louis-Joseph Dufour et ses successeurs auront le droit de passer pour communiquer avec le chemin privé du dit Edmond Savard qui passe entre le terrain ayant appartenu a Joseph Tremblay et celui de Thomas-Louis Boily pour communiquer a la rue St-André, et par lequel chemin privé ledit Louis-Joseph Dufour et ses successeurs auront aussi droit de passer.b) Un autre terrain formant partie du lot 79, mesurant en front 40 pieds sur 90 pieds de profondeur et borné: en front, à la rue St-André; au nord, au terrain ci-dessus décrit; en arrière, au terrain d'Edmond Savard; et au sud, à une lisière do terrain do 33 pieds de largeur appartenant à Edmond Savard que ce dernier utilise comme chemin par lequel Louis-Joseph Dufour et ses successeurs auront droit de passer pour leur besoin.2.Georges-Henri Fortin: Un terrain mesurant 45 pieds de front par 85 pieds do profondeur, faisant partie du lot 87, borné comme suit: En front à la rue St-Pascal; en arrière à la balance de ce lot; d'un côté au nord, au terrain des représentants de Méridé Fillion; et do l'autre côté, au 6ud, à la rue Prince-Albert, ou le lot numéro 92.3.Joseph-Arthur Desgagné: Lo lot 46.4.Pitre Gilbert: La moitié indivise d'un terrain formant partie du lot 133, mesurant approximativement 60 pieds de front sur approximativement 83 pieds de profondeur, et de la approximativement 110 pieds de front sur approximativement 62 pieds de profondeur, compris dans les limites suivantes: Borné en front ou vers le sud, partie par lo chemin public du rang St-Jean et partie par le terrain d'Adjutor Potvin ou représentants; en arrière, vers le nord, par le terrain appartenant à madame Pitre Gilbert ou représentants et tel que clôturé; d'un côté, vers l'est, partie au terrain d'Adjutor Potvin ou représentants et partie au terrain de Léandre Dallaire ou représentants tel qu'occupé, ot do l'autre côté, vers l'ouest, partie au terrain de Jean-Baptiste Ouollot ou représentants et partie du terrain do madame Pitre Gilbert ou repré- ing the same and subject mainly to flooding rights and servitudes belonging to the Saguenay Power Co., or representatives.The purchase price of each of the said immovables will be payable immediately.The sale shall, moreover, be subject to right of redemption and to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at St.Joseph d'Alma, this 12th day of April, 1950.J.L.ROMÉO JOBIN, 27350-17-2 Secretary-Treasurer.Province of Quebec, District of Chicoutimi Municipality of the Village of Saint-Alexis de la Grande-Baie Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the twentieth day of April, 1950, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1941, chapter 207) to sell the immovables hercinbelow designated in payment of arrears of taxes due to the corporation of the village of Saint-Alexis de la Grandc-Baic, with interest and costs, and that consequently the said immovables will be sold, by public auction, in the council hall, in the town hall of Saint-Alexis-dc-la-Grande-Baie, on the TWENTY-SIXTH day of MAY, 1950, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).However, there will be excluded from the sale those immovables whereon all municipal taxes for the year 1949 and previous years shall have been paid before the sale.1.Louis Joseph Dufour: a) A lot of land forming part of lot 79, measuring 36 feet in front by about 170 feet in depth, bounded by and contained within the following limits: In front, by St-André street; in rear by tho land of Edmond Savard; on one sido to the north by the land of David Lavoic or representatives; and on the other side, to the south, partly by tho land secondly described and belonging heretofore to Joseph Tremblay, and upon which lot of land of said Edmond Savard and others, the said Louis Joseph Dufour and his successors shall have right of way to communicate with the private road of said Edmond Savard which passes between the land which belonged to Joseph Tremblay and that of Thomas Louis Boily to communicate with St-André street, and through which private road the said Louis Joseph Dufour and his successors shall also have the right to pass.b) Another lot of land forming part of lot 79, measuring 40 foot in front by 90 feet in depth, and bounded: In front, by St-André street; on the north, by the land above described; in rear, by tho land of Edmond Savard; and on the south, by a strip of land 33 feet wide belonging to Edmond Savard which the latter uses as a road over which tho said Louis Joseph Dufour and his successors shall have the right to pass as and when needed.\u2022 2.Georges Henri Fortin: A lot of land measuring 45 feet in front by 85 feet in depth, forming part of lot &7, bounded as follows: In front by St-Pascal street; in rear by the balance of said lot; on one side, to the north, by the land of the representatives of Méridé Fillion; and on the other side, to tho south, by Prince-Albert street, or lot No.92.3.Joseph Arthur Desgagné: Lot 46.4.Pitre Gilbert: The undivided half of a lot of land forming part of lot 133, measuring approximately 60 feet in front by approximately 83 feet in depth, and thence approximately 110 feet in front by approximately 62 feet in depth, comprised within the following limits: Bounded in front or towards the south, partly by the public road of the St-Jean rango and partly by the land of Adjutor Potvin or representatives; in rear, towards the north, by the land belonging to Madame Pitre Gilbert or representatives, and as fenced in; on one sido, to tho east, partly by the land of Adjutor Potvin or representatives and partly by the land of Léandre Dallaire or representatives as occupied, and on the other side, to tho west, partly by the land of Jean Baptiste Ouellet or representatives and partly by the land of Madame Pitre Gilbert or representatives QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, I960, Vol.82, No.17 1247 sentants et tel que clôture; avec réserve en faveur de The Ha ! Ha ! Bay Sulphite, Limited ou sa représentante des droits lui appartenant et relatifs h une conduite d'eau de deux pieds de diamètre passant dans l'angle nord-ouest de ce terrain.5.Joseph Simard, Féréol: a) Un terrain mesurant 42 pieds de front sur 40 pieds de profondeur, borné on front ou i\\ l'est, n la rue St-Pascal; on arrière ou vers l'ouest, au terrain plus bns décrit; d'un côté, au nord, au lot 78, et de l'autre côté, au sud, au surplus du dit lot 80.b) Un terrain mesurant 52 pieds de Inrgeur en arrière, sur 75 pieds de profondeur, ci borné on front ou à l'est, partie au terrain en premier lieu décrit, et partie au surplus du dit lot 80; en arrière ou & l'ouest, et du côté sud, au surplus du mémo lot 80; du côté nord, partie au lot 78 et partie au lot 77;, une bande de terre «le 9 pieds de largeur dans la partie sud du terrain déerit plus haut et désigné a l'alinéa a) et m bordure d'un petit emplacement situé au sud qui appartient à Maurice Girard ou représentants, sert de passage commun ot à perpétuité du dit Maurice Girard ou représentants ou ayant droits.Les lots ou partie de lots désignés ci-dessus, aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 sont ainsi connus et désignés aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du village de Grande-Baie, paroisse de St-Alcxis.G.Guillaume Gagné: Le lot 93-55.7.Albéric Levesque: Un terrain mesurant 50 pieds de front par 100 pieds de profondeur, faisant partie du lot 92, borné comme suit: En front, au chemin public, du côté nord, à la balance de ce lot; du côté sud au terrain de Conrad Lavoic; et a la profondeur, en arrière, au terrain do la Compagnie de Chemin de Fer Uoberval-Snguenay.8.Philippe Gagné: Un terrain faisant partie du lot 93 d'uni' grandeur de 150 pieds de front sur une profondeur d'environ 100 pieds, borné au nord, au terrain de Théodc Tremblay; au sud, a la balance du terrain restant a Gilles Tremblay ou représentants et faisant partie de ce môme lot; à l'est, au terrain de la Cie de Chemin de Fer Robcrval-Saguenay; et à l'ouest, au chemin public actuel.9.Georges-Henri Tremblay, fils d'Emile: Un terrain formant partie des lots 94 et 479 compris dans les limites suivantes: En front, vers le sud-ouest, par le chemin public; on arrière, vers le nord-est par le terrain do la Cie de Chemin de Fer Roberval-Sagucnay; d'un côté, vers le nord-ouest, par le terrain de la Société de Construction Ouvrière do Chicoutimi qui est le lot numéro 94-11 ou représentants, et de l'autre côté, vers le sud-est, par le terrain de Joseph-Arthur Gauthier tel quo rectifié et borné par acte entre M.Emile Tremblay, M.Marc Gauthier et M.J.-A.Gauthier, reçu le 13 septembre 1921, devant A.-P.Dufour, notaire, sous le No 5,704 de ses minutes.10.Vvo Georges Tremblay, Abel: a) Les lots 94-170, 94-177 ot 94-242.6) Une lisière de terrain de 2]/% pieds de largeur, du sud au nord, sur une profondeur de 50 pieds, de l'est à l'ouest, formant partie du lot 94-175, bornée: on front, à l'est, au lot 94-174; en .arrière, à l'Ouest, ainsi que du côté nord, au terrain appartenant à Albert Bergevin ou résidu du dit lot 94-175; de l'autre côté, au sud, au lot 94-170.11.Rosario Simard.La moitié indivise de: a) Un terrain formant partie du lot 00 borné comme suit: en front ou à l'ouest, par le Barachois au sud par le terrain des représentants de Johnny Simard; au nord par une ligne partant d'un point situé à 32 pieds au sud du pont et au bord de la rivière qu'il y a au fond du Barachois, lorsque la mer est basse, et se dirigeant ladite ligne dans uno direction sud-est, a peu près, jusqu'au point situé a 183 pieds du point de départ et à 113 pieds au sud-ouest du chemin du cimetière; à l'est par uno ligne partant du point d'arrière de la précédente et so dirigeant dans uno direction sud, à peu près, jusqu'au terrain des représentants de Johnny Savard; lo point situé à 460 pieds du point de départ do cette ligne se trouve éloigné de 100 pieds de la rivière qu'il y a au fond du Barachois quand la mer est basse, la mesure 80 prenant de ce point et en gagnant la rivière dans la direction de l'est à l'ouest.b) Un autre terrain faisant partie du lot 60 susdit, do 26J4 pieds do largeur sur environ 38 pieds de longueur borné: au nord, par le chemin du cimetière; au sud, par lo terrain plus haut décrit; à l'ouest, par une ligne parallèle à la rivière qu'il y a au fond du Barachois 3uand la mer est basj>e et distante do 45 pieds du bord e ladite rivière, et à l'est, par une ligne parallèle à la ligne ouest et distante de 26H pieds de la ligne ouest; c) Un terrain faisant partie du lot 00 borné: au nord, par une ligne parallèle partant du point situé à 460 pieds du point do départ de la ligne plus haut décrite (paragraphe a) à l'est, et se dirigeant de là à la ligne bornant au nord le terrain ci-dessus décrit and as fenced in; with reserve in favour of Tho Ha ! Ha ! Bay Sulphite, Limited or its representatives of .the rights belonging to it with respect to a water pipe two feet in diameter passing in the northwest corner of the said lot of land.5, Joseph Simard, Féréol: a) A lot of land measuring 42 feet in front by 40 feet in depth, bounded in front or to the east, by St-Pascal street; in rear or towards the west, by the land below described; on one side, to the north, by lot 78, and' on tho other side, to tho south, by the surplus of said lot 80.b) A lot of land measuring 52 feet in width in rear, by 75 feet in depth, and bounded in front or to tho cast, partly by the land firstly described and partly by the surplus of said lot 80; in rear or to the west, and on the south side, by the surplus of same lot 80; on the north side, partly by lot 78 and partly by lot 77; a strip of land 9 feet wide in the south part of the lot of land above described in paragraph a) and bordering a small emplacement situate on the south which belongs to Maurice Girard or representatives, serves as a common passage in perpetuity for said Maurice Girard or representatives or assigns.The lots or parts of lots above described in numbers 1, 2, 3, 4 and 5 as known and designated as such on the official cadastral plan and in the book of reference for the village of Grande-Baie, parish of St-Alexis.0.Guillaume Gagné: Lot 93-55.7.Albéric Levesque: A lot of land measuring 50 feet in front by 100 feet in depth, forming part of lot 92, bounded as follows: In front, by the public road, on the north side, by the residue of said lot; on the south side by the land of Conrad Lavoic; and at the depth, in rear, by the land of the Robcrval-Saguenay Railway Company.8.Philippe Gagné: A lot of land forming part of lot 93, measuring 150 feet in width in front by a depth of about 100 feet, bounded on the north, by the land of Théodc Tremblay; on the south, by the balance of the land remaining to Gilles Tremblay or representatives and forming port of the same lot; on the east, by the land of the Robcrval-Saguenay Railway Company, and on the west by the present public road.9.Georges Henri Tremblay, son of Emile: A lot of land forming part of lots 94 and 479 comprised within the following limits: In front, towards the southwest, by the public road; in rear, towards the northeast by the land of the Robcrval-Saguenay Railway Company; on one side, to tho northwest, by the land of the \"Société de Construction Ouvrière de Chicoutimi\" which is lot No.94-H or representatives, and on tho other side, to the southeast, by the land of Joseph Arthur Gauthier as rectified and bounded by deed between Mr.Emile Tremblay, Mr.Marc Gauthier and Mr.J.A.Gauthier, passed the 13th of September, 1921, before A.P.Dufour, Notary, under No.5,704 of his Minutes.10.Wid.Georges Tremblay, Abel: a) Lots 94-170, 91-177 and 94-242.b) A strip of land 2}^ feet wide, from south to north, by a depth of 50 feet from east to west, forming part of lot 94-175, bounded: In front, to the east by lot 94-174; in rear, to the west, and on the north side, by the laud belonging to Albert Bergevin or residue of said lot 94-175; on the other side, to the south, by lot 94-176.11.Rosario Simard: The undivided half of a lot of land forming part of lot 00 bounded as follows: In front or to the west by the \"Barachois\", on the south by the land of the representatives of Johnny Simard; on the north by a line starting at a point situate at 32 feet south of the bridge and on the border of tho river which exists in the bed of the Bnrachois at low tide, and the said line running southeastward, or thereabouts, to a point situate at 183 feet from the starting point and at 113 feet southwest of the cemetery road; on tho east by a line starting from the point in rear of tho preceding and running southward, or thereabouts, to the land of tho representatives of Johnny Savard; the point situate at 400 feet from the starting point of the said line is about 100 feet from the river which exists in the bed of the Barachois at low tide, the measurement being taken from this point and running to the river in an easterly and westerly direction.b) Another lot of land forming part of lot 06 aforesaid, measuring 2G>^ feet in width by about 38 feet in length, bounded: On the north, by the cemetery road; on the south, by the land above described; on the west, by a line parallel to tho river which exists in tho bed of tho Barachois at low tide and 45 feet from tho border of the said river, and on the east, by a line parallel to the west line and 2GH feet from the west line; c) A lot of land forming part of lot 66, bounded: On the north, by a lino parallel to the starting point situate at 460 feet from the starting point of the line above described (paragraph a) on tho east, and thenco running to the line bounding on the north the land 1248 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1960, Tome 82, N° 17 (paragraphe «), en suivant uno direction de l'ouest à 1^-st jusqu'à un point situé à 1G5 pieds, et gagnant lo sud jusqu'à uno distance do GO pieds; au sud, par uno ligno partant du point d'arrivée de cette ligne de GO pieds et gagnant à l'ouest jusqu'à uno distance do 70 pieds, et de là gagnant lesud-ouest jusqu'au point de rencontre do la ligne des représentants de Johnny Savard.Ce terrain et la partie de ceux décrits en premiers lieux comme formant partie du lot GG susdit, sont maintenant connus et désignés sous lo lot GG-4 de la paroisse de St-Aloxis de Grande-Baie.d) Les droits et intérêts do J.Morgan sur un terrain formant partie du lot cadastral G5, borné en front nu Barachois; on arrière, au chemin public; du côté sud, au pont ot au nord, au prolongement vers lo nord-ouest do la ligne nord-est do l'emplacement des représentants de Joseph l'âgé, du côté sud-ouest du chemin.12.Albert Gagnon: Le lot 94-106.Les lots ou partie de lots désignés ci-dessus, aux numéros d'ordre G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sont ainsi connus et désignés aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel do la paroisse do St-Alexis de la Grande-Baie.Tous ces immeubles-seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en a.I^e prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatenmt.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné a St-Alexis-de-la-Grande-Baie, le 21ième jour d'avril 1950.Ix' Secrétaire-trésorier, 27379- 17-2-o WILLIE TREMBLAY.Province de Québec \u2014 District de Chicoutimi Municipalité du canton Bouiuïet Avis public est par les présentes donné que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du vingt avril 1950, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dus à la corporation municipale du canton Bourgct, avec intérêt et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public, dans la salle du conseil de canton Bourget, le VINGT-CINQ MAI 1950, à ONZE heures de l'avant-midi, heure avancée.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales de l'année 1949 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.1.Lionel Gauthier: Un emplacement formant partie du lot 28, rang 1, lequel terrain mesure 75 pieds de largeur, de l'est à l'ouest, sur une profondeur de 125 pieds, du sud au nord, et est borné: au nord, par le terrain de M.Israël Simard ou représentants; au sud, par le chemin public; d'un côté, vers l'est, par le terrain de M.Ernest Boulet ou représentants et de l'autre côté, vers l'ouest, par le terrain de M.Wilfrid Simard ou représentants.2.Laurent Bergeron: Le lot 34, rang 3.3.Thomas-Louis Bergeron: Le lot 37, rang 3.4.Ludger Girard: a) Le lot 45, rang 4.b) Le lot 46, rang 4, à titre très précaire.5.Siméon Racine: Une maison située sur partie du lot 29, rang 1.Tous les lots ou parties de lots ci-dessus sont connus et désignés aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton Bourget et seront vendus avec bâtisses dessus construites, circons- above described (paragraph a), and following a direction west to east up to a point situate at 165 feot and running south for n distance of 60 feet; on the south, by a lino starting from the finishing point of tho said lino of GO feet and running west for a distance of 70 feet, and thence running southwest as far as the meeting point of the line of the representatives of Johnny Savard.The said lot of land and tho part of those firstly described as forming part of lot GG aforesaid, are now known and designated as lot 66-4 of tho parish of St-Alcxis de Grande-Baie.d) Tho rights and interests of J.Morgan on a lot of land forming part of cadastral lot G5 bounded in front by tho Barachois; in rear, by the public road, on the south side, by the bridge and on tho north, by tho prolongation northwestward of tho northeast line of tho emplacement of the representatives of Joseph Page, on tho southwest side of the road.12.Albert Gagnon: Lot 94-196.Tho lots or parts of lots above designated numerically from G, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, are known and designated as such on the official cadastral plan and in tho book of reference for the parish of St-Alexis de la Grande-Baio.All the saiid immovables will be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any.The purchase price of each of the said immovables will be payable immediately.The sale shall moreover be subject to right, of redemption ami to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at St-Alcxis-de-la-Grande-Baie, this 21st day of April, 1950.WILLIE TREMBLAY, 27379-17-2 Secretary-Treasurer.Province of Quebec \u2014 District of Chicoutimi Municipality of the Township Bouroet Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the twentieth of April, 1950, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1941, chapter 207), to sell the immovables hereinbelow designated in payment of arrears of taxes due the municipal corporation of the township Bourget, with interest and costs, and that consequently the said immovables will be sold by public auction, in the council hall of the township Bourget, on the TWENTY-FIFTH day of MAY, 1950, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).However, there will be excluded from the sale, those immovables whereon the municipal taxes for the year 1949 and previous years, shall have been paid before the sale.1.Lionel Gauthier: An emplacement forming part of lot 28, range 1, the said lot of land measures 75 feet in width, from cast to west, by a depth of 125 feet, from south to north, and is bounded: on the north, by the land of Mr.Israel Simard or representatives; on the south, by the public road; on one side, to the east, by the land of Mr.Ernest Boulet or representatives and on the other side, to the west, by the land of Mr.Wilfrid Simard or representatives.2.Laurent Bergeron : Lot 34, range 3.3.Thomas Louis Bergeron: Lot 37, range 3.4.Ludger Girard: a) Lot 45, range 4.b) Lot 46, range 4, of precarious title.5.Simeon Racine: A house situate on part of lot 29, range 1.All the lots or parts of lots above described are known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the township Bourget and will be sold with buildings QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, I960, Vol.82, No.17 1249 tances et dépendances, s'il y a lieu, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes attachées auxdits immeubles.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Saint-Charles, ce 21ièmc jour du mois d'avril 1950.Le Secrétaire-trésorier, 273S5-17-2-0 EDOUARD GAUTHIER.thereon erected, circumstances and dependencies, if any, and with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immovables.The purchase price of each of the said immovables will be payable immediately.The sale shall, moreover, be subject to right of redemption and to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at Saint-Charles, this 21st day of the month of April, 1950.EDOUARD GAUTHIER, 27385-17-2 Secretary-Treasurer.Actions en séparation de biens Canada, province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No.281 417.Dame Jeanne Richard, demanderesse vs Gérard Jean, défendeur.Dame Jeanne Richard, épouse de Gérard Jean, typographe, des cité et district de Montréal, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Montréal, le 17 avril, 1950.Les Procureurs de la demanderesse.27332-0 JOHNSON & TORMEV.Province de Québec, district de Montréal, cour supérieure, No.284530.Dame Simone Martin épouse commune en biens de Isaïe Boyer contracteur, des cité et district de Montréal, demanderesse vs Isaïe Boyer contracteur, des mêmes lieux, défendeur.Prenez avis que Dame Simone Martin épouse commune en biens de Isaïe Boyer contracteur, des cité et district de Montréal au numéro 7491 rue St-Hubert, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Montréal, le 12 avril 1950.Les Procureurs de la demanderesse, 27331-o Fauteux, Blain & Fauteux.Province de Québec, District de Montréal.Cour Supérieure, N° 284,785.Dame Marie-Rose Diana Bédard, épouse commune en biens de Giovanni Battista Ciot, de Montréal, demanderesse, vs Ledit Giovanni Battista Ciot, de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée contre le défendeur, jeudi le 20 avril 1950.Montréal, 22 avril 1950.Les Procureurs de la demanderesse, Bertrand.Grégoire & 27333-o Dansereau.Province de Québec, district de Joliette, Cour supérieure, N° 9563.Dame Laurctte d'Amour, de Rawdon, district de Joliette, épouse commune en biens de Joseph-Henri-Paul Rivet, commis-voyageur, des mêmes lieux, demanderesse, vs Ledit Joseph-Henri-Paul Rivet, commis-voyageur, de Rawdon, district de Joliette, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée par la demanderesse contre le défendeur.Joliette, ce 24 avril, 1950.Les Procureurs de la demanderesse, Prévost, Montpetit, Noël, 27353-o Desjardins & Ducharme.Actions for separation as to property Canada, Province of Quebec.District of Montreal, Superior Court, No.281 417.Dame Jeanne Richard, plaintiff; vs Gérard Jean, defendant.Dame Jeanne Richard, wife of Gérard Jean, typographer, of the city and district of Montreal, has taken against her husband an action for separation as to property.Montreal, April 17, 1950.JOHNSON & TOR ME Y, 27332 Attorneys for the plaintiff.Province of Quebec, district of Montreal, superior Court.No.284530.Dame Simone Martin, wife common as to property of Isaïe Boyer, contractor, of the city and district of Montreal, plaintiff; vs Isaïe Boyer, contractor, of the same place, defendant.Take notice that Dame Simone Martin, wife common as to property of Isape Boyer, contractor, of the city and district of Montreal, number 7491 St.Hubert Street, has taken an action against her husband for separation as to property.Montreal, April 12, 1950.Fauteux, Blain & Fauteux, 27331 Attorneys for the plaintiff.Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.2S4785.Dame Marie-Rose Diana Bédard, wife common as to property * of Giovanni Battista Ciot, of Montreal, plaintiff; vs the said Giovanni Battista Ciot, of Montreal, defendant.An action for separation as to property was entered against the defendant, on Thursday, April 20, 1950.Montreal.April 22, 1950.Bertrand, Grégoire & Dansereau.27333 Attorneys for the plaintiff.Province of Quebec, district of Joliette, Superior Court, No.9563.Dame Laurette d'Amour, of Rawdon, District of Joliette, wife common as to property of Joseph-Henri-Paul Rivet, commercial traveller, of the same place, Plaintiff, vs The said Joseph Henri Paul Rivet, commercial traveller, of Rawdon, District of Joliette, Defendant.An action in separation as to property has been instituted by the Plaintiff against the Defendant.Joliette, April 24th, 1950.Prévost, Montpetit, Noël, Desjardins & Ducharme, 27353-o Attorneys for plaintiff. 1250 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 Canada, province de Québec, district de Bedford, Cour Supérieure, N° 3268.Dame Claire Lagimonière, de la Cité de Granby, district de Bedford, épouse commune en biens de Philippe Touchctte, entrepreneur en couverture, des mêmes lieux et endroits, demanderesse, vs Ix>dit Philippe Touchctte, entrepreneur en couvertures, des mêmes lieux et endroit, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le 17 avril 1950.Sweetsburg, ce 24ièmc jour d'avril 1950.Le Procureur de la demanderesse, 27363-Q GEO.-H.DUREAULT.Action en séparation de corps et de biens Canada, province de Québec, district de Ri-mouski, Cour Supérieure, No.11554.Dame Rose Ix*vesque.épouse commune en biens de Aurèle Levesque, domiciliée à St-Robert Bellar-min, dans la ville de Rimouski, a formé une demande en séparation de corps et biens contre son mari Aurèle Levesque, de St-Robert Bcllar-min.Rimouski.ce 21 avril, 1950.Les Procureurs de la demanderesse, 27331 GENDREAU & BEAULIEU.Avis divers Avis est, par les présentes, donné que l'honorable Secrétaire de' la Province a dûment reçu un des triplicata de la déclaration de fondation de la \"Coopérative d'Electricité de l'Abitibi-Est\", en date du 2 avril 1950, dont le siège social est situé à Barrante, dans le comté d'Abitibi, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi de l'élcctri-fication rurale (9 George VI.chapitre 48).Donné au bureau du Secrétaire de la Province \u2022le 22 avril 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27335-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 19 avril 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Bromptonville Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Lois des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 20 avril 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27336-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS DIVERS Avis est donné au public par les présentes conformément à l'article 35 de la loi du Régime des Eaux Courantes que Adélard Goyette de Rivière Canada, province of Quebec, district of Bedford, Superior Court, No.3268.Claire Lagimonière, of Granby, district of Bedford, wife common as to property of Philippe Touchctte, roof contractor, of the same place, plaintiff, vs The said Philippe Touchctte, of the same place, defendant.An action in separation as to property has been entered in this case, on the 17th day of April 1950.Sweetsburg, this 24th., dav of April 1950.GEO.H.DUREAULT, 27363-0 Attorney for the plaintiff.Action for Separation as to Bed and Board and Property Canada.Province of Quebec, District of Rimouski, Superior Court No.11554.Dame Rose Levesque, wife common as to property of Aurèle Levesque, domiciled at St-Robert Bellar-iiiin.in the town of Rimouski, has taken an action for separation as to bed and board, against her husband Aurèle Levesque, of St-Robert Bcllarmin.Rimouski, April 21, 1950.GENDREAU & BEAULIEU.27334 Attorneys for the plaintiff.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received one of the triplicates of the declaration of foundation of the \"Coopérative d'Electricité de l'Abitibi-Est\" under date the second day of April, 1950, whereof the head office is at Barraute, county of Abitibi, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 22 of the Rural-Electrification Act (9 George VI, chapter -IS).Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-second day of April.1950.JEAN BRUCHÉSI, 27335 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary under date of April 19, 1950, has enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Bromptonville Inc\", and such in conformity with the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secrctarv, April 20, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27336 Under Secretary of the Province.MISCELLANEOUS NOTICE Public notice is hereby given, in accordance with Section 35 of the water course act, that Adélard Goyette of Rivière à Pierre in the coun- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1251 à Pierre comté de Portneuf se propose de faire exécuter les travaux suivants: De faire construire un barrage pour faciliter le flottage des billots sur la Rivière à Pierre, au Lac du Dépôt sur le lot N° 10 Rang 1 & 2 dans le Canton de Bois.Avis est aussi donné qu'une pétition à cet effet, accompagnée par lés plans et spécification indiquant la nature de la construction et les terrains qui seront affectés par telle construction, a été adressé au Ministère des Terres et Forêts et qu'un duplicata de tels plans et spécifications a été déposé au bureau d'enregistrement de la division de Portneuf a Cap Santé, Que.L'application contenue dans la pétition sera prise en considération par le Lt.Gouverneur en Conseil le ou après le lOième jour suivant la date de la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Rivière à Pierre, Que.le 19 avril 1950.27337-Q ADELARD GOYETTE.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-.lcan Port Joli\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 25 mars 1950.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Jean-Port-Joli, comté de LTslet.Le Sous-secrétaire de la Province, 27338-0 JEAN BRUCHÉSI.ty of Portneuf intends to execute the following works: Erect a dam for facilitating the driving of logs on Rivière à Pierre on Lake du Dépôt on Lot No.10 Range 1 & 2 in the Township of Bois.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specification, showing the nature of the works and the land which will be affected by such work has been forwarded to the Minister of Lands and Forests, and that a duplicate of such plans and specifications has been deposited at the Registry Office of the registration division of Portneuf at Cap Santé, Que.The application contained in the petition will be taken into consideration by the Lt.Governor in Council on or after the 10th day following the date of the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Rivière à Pierre.Que., April 19th.1950.27337-0 ADÉLARD GOYETTE.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Jean Port Joli\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on March 25.1950.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Jean-Port-Joli, countv of L'Islet.JEAN BRUCHÉSI.27338 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"The Rivcrvicw Credit Union Limited\", en date du 3 mars 1950, dont le siège social est situé à Ville LaSalIe, district judiciaire de Montréal, et (pic ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 6 mars 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27339-Q JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"The Riverview Credit Union Limited\" under date the third day of March, 1950, whereof the head office' is at Town of LaSalle, judicial district of Montréal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixth dav of March, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27339 Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 24 avril 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Syndicat National Catholique des Maîtresses Coiffeuses des Trois-Rivières & District\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 26 avril 1950.Le Sous-;Sccrétaire de la Province, 27366-0 JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has enacted-, on the 24th of April, 1950, the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Syndicat National Catholique des Mattresses Coiffeuses des Trois-Rivières & District\", and such, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162.as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given ^at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of April, 1950.^ JEAN BRUCHÉSI, 27366 Under Secretary of the Province. 1252 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 Avis d'érection en municipalité de ville A qui de droit: Le conseil de la municipalité du village de Mont-Laurier, comté de Labelle, province de Québec, donne par les présentes avis de son intention d'ériger la municipalité du village de Mont-Laurier en Municipalité de ville.a) Le nom de la municipalité projetée sera \"La Municipalité de la ville de Mont-Laurier\".6) Le territoire de ladite municipalité de la ville de Mont-Laurier comprendra: \"La partie ouest de chacun des lots numéros 20 à 26 inch du rang 1 du canton de Campbell ainsi que les deux îles de la rivière du Lièvre, situées en face des lots numéros 23 et 22 du dit rang et elle est bornée comme suit, savoir: Au nord, par le lot numéro 27 du dit rang; au sud par le lot no.19 du même rang; à l'est, par une ligne droite menée transversalement aux dits lots numéros 20 à 26 à partir du point où la ligne séparation des lots numéros 19 et 20 du dit rang rencontre la rive gauche du ruisseau Villemairc de manière à joindre les deux bornes en bois de chêne, plantées l'une sur la ligne séparation Lots 19 et 20 et l'autre sur celle des lots 26 et 27, pour indiquer la limite est de la dite municipalité; enfin, vers l'ouest, par la ligne de profondeur des eaux dans la dite rivière du Lièvre, sera détachée de la municipalité du Canton de Campbell, et formera une municipalité séparée sous le nom de la \"Municipalité du Village de Mont-Laurier.\" 1) les lots nos.52 et 53 du rang II du canton Robertson; 2) les lots nos.51, 52 et 53 du rang III, même canton.c) Le recensement de la population «lu village de Mont-Laurier s'établit à 4,485 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq) âmes, tel que constaté par un recensement ordonné par le conseil, le 17 février 1950; d) L'érection de la municipalité de la ville de Mont-Laurier se fera sous l'empire de la Loi des Cités et Villes, Ch.233 S.R.P.Q.1941 et ses amendements.Et le présent avis est publié à toutes fins (pic de droit.Mont-Laurier, ce 20 avril 1950.Le Secrétaire-trésorier de la municipalité du village de Mont-Laurier.27348-17-4-0 LÉO PAQUETTE.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le 14 avril 1950, le changement de nom de \"Le Syndicat National des Travailleurs de St-Félicien\" en celui de \"Syndicat Industriel des Métiers de la Construction de St-Félicien\", et ce conformément aux dispositions de l'article 7 de la I.«oi des syndicats professionnels.S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 15 avril 1950.Sous-secrétaire de la Province, 27369-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice of Erection into a Town Municipality To whom it may concern: The council of the municipality of the village of Mont-Laurier, county of I.allelic Province of Quebec, hereby gives notice *of its intention to erect the municipality of the village of Mont-Laurier into a Town municipality.a) The name of the proposed municipality to he \"The Municipality of the Town of Mont-Laurier\".b) The territory of the said municipality of the town of Mont-Laurier will consist of : \"The west part of each of lots numbers 20 to 26 inch, of range 1 of the Township of Campbell and also the two islands of the \"du Lièvre\" river, situate in front of lots numbers 23 and 22 of said range and it is bounded as follows, to wit: on the north, by lot number 27 of said range; on the south by lot No.19 of the same range; on the east, by a straight line drawn transversally to said lots numbers 20 to 26 starting from the point where the division line of lots numbers 19 and 20 of said range meets the left bank of the Villemaire stream so as to join the two oak wood boundaries planted, one on the division line of lots 19 and 20 and the other on that of lots 26 and 27, to indicate the east limit of the said municipality; finally, towards the west, by the depth line of the waters of the said river \"du Lièvre\", to be detached from the municipality of the Township of Campbell, and to form a separate municipality under the name of the \"Municipality of the Village of Mont-Laurier.\" 1) Lots Nos.52 and 53 of range II of the township Robertson; 2) Lots Nos.51, 52 and 53 of range III.same township.c) The census of the population of the village of Mont-Laurier is established at 4,485 (four thousand four hundred and eighty-five) souls, as ascertained by a census ordered by the Council, on the 17th of February, 1950; d) The erection of the municipality of the Town of Mont-Laurier shall be made tinder the authority of the Cities and Towns Act, chapter 233, R.S.Q., 1941 and its amendments.And the present notice is published to all intents and purposes.Mont-Laurier, April 20, 1950.LÉO PAQUETTE, Secretary Treasurer of the Municipality 27348-17-4 of the Village of Mont-Laurier.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of April 14, 1950, authorized the change of name of \"Le Syndicat National des Travailleurs de St-Félicien\", to that of \"Syndicat Industriel des Métiers de la Construction de St-Félicien\" and such in conformity with the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, April 15, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27369 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1253 AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Pierre Ile Orléans\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 14 mars 1950.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Pierre, Ile d'Orléans, comté de Montmorency.I^e Sous-secrétaire de la Province, 27352-0 JEAN BRUCHÉSI.Aluminum Club of Montreal Extrait des règlements du club mentionné ci-dessus, approuvé à l'unanimité par les membres, concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs de trois à neuf: \"Article V \u2014 Directeurs \u2014 section 1.Le contrôle et l'administration du club et de ses biens seront confiés à un bureau de direction composé de trois femmes et six hommes élus conformément aux dispositions de l'article IV.\" Approuvé à l'unanimité par les membres, le 7 juin 1949.Le Président, 27354 (Signé) THOS.-C.FRASER.Avis est donné que, sur la recommandation de P Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 6 avril 1950, les règlements généraux de \"La Chambre de Commerce des Jeunes de St-Raymond\", comprenant les articles 1 à 14 inclusivement, et le règlement numéro II,'augmentant le nombre de ses directeurs de sept à dix, et ce conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 11 avril 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27368-Q JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professionnal Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Pierre Ile Orléans\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on March 14, 1950.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Pierre, He d'Orléans, county of Montmorency.JEAN BRUCHÉSI, 27352 Under Secretary of the Province.Aluminum Club of Montreal Extract of the by-laws of the above mentioned club, as unanimously approved by the members, concerning the increase of the number of director thereof from three to nine: \"Article V \u2014 Directors \u2014 Section 1.The control and management of the Club and its property shall be vested in a Board of Directors composed of three women and six men elected in accordance with the provisions of Article IV.\" Approved by the Members unanimously, 7th June, 1949.(Signed) THOS.C.FRASER, .27354-0 President.Notice is given that upon recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary, under date of April 6, 1950, approved the general By-laws of \"La Chambre de Commerce des Jeunes de St-Raymond\" including articles 1 to 14 inclusively, and By-law number II, increasing the number of its directors from seven to ten, and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act, R.S.Q.1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary, April 11, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27368 Under Secretary of the Province.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Avis de demande d'abandon Notice of Application for Surrender of de charte charter Conformément aux dispositions de la Loi Under the provisions of the Quebec Compa- des compagnies de Québec, la compagnie \"Jeni- nies' Act, \"Jeni-Lee Incorporated\" hereby gives Lee Incorporated\" donne, par les présentes, avis public notice that it will make application to the public qu'elle s'adressera au Procureur général, Attorney General and to the Minister of Munici- et au Ministre des affaires municipales, de Pin- pal Affairs, Trade and Commerce for leave to dustrie et du commerce pour obtenir la permis- surrender its charter and to be declared dissolved, sion d'abandonner sa charte ainsi que sa dissolution.* Daté à Montréal, le 18 avril 1950.Dated at Montreal, this 18th day of April, 1950.Par ordre du bureau de direction.By order of the Board of Directors.Le Procureur de la Compagnie, HAROLD S.FREEMAN, 27340 HAROLD S.FREEMAN.27340-o Attorney for the Company.* Welsh Agencies Limited Welsh Agencies Limited Avis est par ces présentes donné que \"Welsh Notice is hereby given under the Quebec Agencies Limited\" a l'intention de faire appli- Companies Act and amendments that \"Welsh cation au Procureur général de la province de Agencies Limited\" intends to apply to the Attor- Québec pour abandon de sa charte.ney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.20 avril 1950.April 20th, 1950.Le Secrétaite-trésorier, JAN PICK, 27341-0 JAN PICK.27341-o Secretary-Treasurer. 1254 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 Lincoln Properties Inc.Avis est donné par les présentes, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec et ses amendements, que la compagnie \"Lincoln Properties Inc.\" demandera au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Le 25 avril 1950.Le Secrétaire, 27304 JOIIX-J.ADELSTEIN.Lincoln Properties Inc.Notice is hereby given under the Quebec Companies' Act and Amendments thereto that \"Lincoln Properties Inc.\", intends to apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.April 25th, 1950.JOHN J.ADELSTEIN, 273G4-0 Secretary.Commission Municipale de Quebec Quebec Municipal Commission La Commission Municipale de Québec Règle de pratique A'° G Adoptée par la Commission municipale de Québec le 11 avril 1950 et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en date du 19 avril 1950.Considérant que, sous l'autorité de l'article 80 et conformément aux prescriptions du paragraphe \"6\" de l'article 49 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, c.207), la Commission municipale de Québec, par sa Règle de pratique N° 3, modifiée par sa Règle de pratique N° 4, a édicté les procédures à faire lorsqu'une municipalité en défaut soumet à ses créanciers un plan de réorganisation financière; Considérant qu'il y a lieu de modifier de nouveau ladite Règle de pratique N° 3.En conséquence, il est décrété ce qui suit: 1° La Règle de pratique N° 3, modifiée par la Règle de pratique N° 4, est de nouveau modifiée en y ajoutant après l'article 2 le suivant: \"2a.Cependant, il ne sera pas nécessaire de convoquer une telle assemblée si des créanciers détenant des créances représentant au moins G7% de la dette totale affectée par ledit plan de réorganisation financière se sont engagés, par écrit, à ne pas s'y objecter.Aux fins d'obtenir cet engagement, la municipalité, ou son représentant dûment autorisé, transmettra à tous les créanciers connus et intéressés dans ledit plan, une lettre explicative accompagnée d'un exemplaire de la formule suivante: Formule d'engagement Je, soussigné, créancier de la municipalité ., acceptant le plan de réorganisation financière tel qu'expliqué dans la lettre que j'ai reçue à ce sujet de la part de ladite municipalité, m'engage, par les présentes, à ne pas m'objecter à l'exécution dudit plan.Je suis détenteur de la ou des créances suivantes: Queuec Municipal Commission Rule of Practice No.6 Adopted by the Quebec Municipal Commission on the 11th day of April, 1950, and approved by the Lieutenant-Governor in Council on the 19th day of April, 1950.Considering that, under authority of section 80 and in accordance with the provisions of paragraph \"6\" of section 49 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1941, chap.207), the Quebec Municipal Commission, by its Rule of practice No.3, amended by its Rule of Practice No.4, has enacted the proceedings to be taken when a municipality in default submits to its creditors a plan of financial reorganization; Considering that it is expedient to again amend the said Rule of practice No.3.Therefore, it is enacted as follows: 1.The Rule of practice No.3, amended by Rule of practice No.4, is again amended by adding the following thereto, after section 2: \"2a.However, it shall not be necessary to call such a meeting if the creditors holding claims representing at least 07% of the total debt affected by the said plan of financial reorganization have agreed, in writing, not to object to it.For the purpose of obtaining such agreement, the municipality, or its duly authorized representative, will transmit to all known creditors interested in the said plan, an explanatory letter accompanied by a copy of the following form: Form of agreement I, the undersigned, creditor of the municipality of.accept the plan of financial reorganization as explained in the letter from the said municipality received by me, and I hereby agree to make no objection to the carrying out of the said plan.I am the holder of the following claim (claims) : Et j'ai signé devant témoin à.And I have signed before a witness at.le.this.Signature du témoin Adresse Signature du créancier Signature of Witness Adresse \" Address Signature of creditor Address 2° Les présentes dispositions seront connues comme étant la Règle de pratique N° 6.3° Ladite Règle de pratique N° 6 entrera en vigueur après approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil et à compter de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 27302-o MAURICE R.MARCOTTE.2.The present provisions will be known as Rule of Practice No.6.3.The said Rule of practice No.6 will come into force after approval by the Lieutenant-Governor in Council on.and from its publication in the Quebec Official Gazette.Certified True Copy.MAURICE R.MARCOTTE, 27302 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1255 Département des Affaires municipales Le soussigné donne avis que, tel que demandé pur une résolution du 3 avril 1950 du conseil du village de St-Sébastien, comté de Frontenac, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a autorisé, en date du 20 avril 1950, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 20 avril 1950.Le Ministre des Affaires municipales, 27342-0 BOXA DUSSAULT.Le soussigné donne avis (pie, tel que demandé par une résolution du 1er avril 1950 du conseil de la paroisse de Ste-Anne de Beaupré, comté de Montmorency N° 1, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a autorisé, en date du 25 avril 1950, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 22).Québec, le 25 avril 1950.Le Ministre des Affaires municipales, 27372-e BOXA DUSSAULT.Le soussigné donne avis que tel (pie demandé par une résolution du 3 avril 1950 du conseil du village de Ste-Anne du Lac, comté de Labelle, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a autorisé, en date du 26 avril 1950, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 26 avril 1950.' Le Ministre des Affaires municipales, 27372-o BOXA DUSSAULT.Department of Municipal Affairs The undersigned gives notice that, as requested by a resolution of the 3rd of April, 1950, of the Council of the village of St-Sébastien, county of Frontenac, and in conformity with the provisions of article 130 of the Municipal Code, he has authorized, under date the 20th day of April, 1950, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required in the QucbecOfficial Gazette, be made, in the future, in the French language only.The present notice is published in conformity with Article 131 of the Municipal Code.(10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, April 20, 1950.« BOXA DUSSAULT, 27342 Minister of Municipal Affairs.The undersigned gives notice, as requested by a resolution of the 1st of April, 1950, of the council of the parish of Ste-Anne de Beaupré, county of Montmorency No.1, and pursuant to the prov-isions of Article 130 of the Municipal Code, he has authorized, under date the 25th of April, 1950, that the publication of all public notices, bylaws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required in the Quebec Official Gazette, be made , in the future, in the French language only.The present notice is published in conformity with Article 131 of the Municipal Code.(10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, April 25, 1950.BOXA DUSSAULT, 27372 Minister of Municipal Affairs.The undersigned gives notice that as requested by a resolution of the 3rd of April, 1950, of the council of the village of Ste-Anne du Lac, county of Labelle.and pursuant to the provisions of Article 130 of the Municipal Code, he has authorized, under date the 26th of April, 1950, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required in the Quebec Official Gazette, be made, in the future, in the French language only.The present notice is published in conformity with Article 131 of the Municipal Code.(10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, April 26, 1950.BOXA DUSSAULT, 27372 Minister of Municipal Affairs.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 50-SP-III Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi, 19 avril 1950, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Lait.'îre, ù Montréal, à 10 heures du matin.Présent: MM.Dr Emile Xadeau, président Omer-E.Milot, Jos Hébert, Adrien Angers, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire.Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.50-Sp-III Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Wednesday, April 19, 1950, held in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Dr Emile Nadeau, President, Omer E.Milot, Jos.Hébert, Adrien Angers, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary. 1256 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 La présente ordonnance s'applique à tout marchand de lait et à tout fournisseur-producteur dans les limites de cette province.Dans la présente ordonnance: Le mot \"fournisseur-producteur\" signifie: a) Toute personne, société, association, compagnie ou corporation, qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau; ou b) Toute société coopérative ou tout syndicat coopératif, formés dans le hut de vendre du lait ou de la crème pour le compte de ses membres et des autres producteurs agissant par son entremise.Les mots \"marchands de lait\" signifient toute personne, société, association, compagnie ou corporation achetant ou recevant, des cultivateurs ou autres producteurs, du lait ou de la crème, soit pour «les revendre à l'état nature, soit pour les transformer pour fins commerciales en crème, crème à la glace, beurre, fromage, lait condensé, lait évaporé, lait en poudre ou autres produits du lait.Attendu qu'en vertu de l'article 26 de la Loi des produits laitiers le marchand de lait et son .fournisseur-producteur ne peuvent mettre fin à leur contrat à moins d'un avis écrit de soixante jours; Attendu que le deuxième alinéa dudit article donne à la Commission le pouvoir de réduire ce délai de soixante jours; La commission* Décrète : A moins d'être liés par un contrat écrit, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle île Québec, tout fournisseur-producteur et tout marchand de lait pourront mettre fin au contrat présumé intervenu entre eux, en donnant un avis écrit préalable de trente jours et en adressant en même temps copie de cet avis à la Commission de l'Industrie laitière.La présente ordonnance annule l'ordonnance N° 43-Sp-XI, publiée dans la Gazette officielle de Québec du 17 avril 1943, et entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Le Secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans le prochain numéro de la Gazette officielle de Québec.Signé: MM.Dr Emile Nadeau, président.Joseph Hébert, Omer-E.Milot, Adrient Angers, Certifié: Alphonse Savoie, Le Secrétaire, Commission 27370-o de l'Industrie Laitière.The present order applies to any milk dealer and any producer-supplier within the limits of this Province.In the present order: The word \"producer-supplier\" means: «) Any person, partnership, association, company or corporation selling or delivering milk or cream from his or its herd; or b) Any cooperative society or cooperative syndicate, formed for the purpose of selling milk or cream for its members or for other producers acting through it.The words \"milk dealer\" mean any person, partnership, association, company or corporation purchasing or receiving milk or cream from farmers or other producers to resell it in its natural state or to convert it for commercial purposes into cream, ice cream, butter, cheese, condensed milk, evaporated milk, milk powder or any other milk product.Whereas, in virtue of article 26 of the Dairy Products' Act.no milk dealer and his producer-supplier may terminate their contract unless a sixty-day notice in writing has been given; Whereas the second paragraph of said article gives to the Commission the power to reduce said delay of sixty days; It is enacted as follows: Unless otherwise bound by a written contract, from the date of the publication of the present order in the Quebec Official Gazette, any milk dealer and producer-supplier may terminate the presumed contract passed between them by giving previously a thirty-day notice in writing, and by transmitting at the same time copy of this notice to the Dairy Industry Commission.The present Order cancels Order Xo.43-Sp-XI, published in the Quebec official Gazette of April 17th, 1943, and shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in the next issue of the Quebec Official Gazette.Signed : Messrs.Dr.Emile Xadeau, president, Joseph Hébert, Omer-E.Milot, Adrien Angers.Certified: Alphonse Savoie, The Secretary, Dairy Industry 27370-o Commission.Département de l'Agriculture Avis est, par les présentes, donné que le ministre de l'Agriculture autorise la formation d'un cercle agricole dans le comté d'Ahitibi-ouest, sous le nom de \"cercle agricole de la paroisse de Sainte-Germaine\", conformément à la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118).Québec, ce 25 avril 1950.Department of Agriculture Notice is hereby given that the Minister of Agriculture authorizes the formation of a Farmer's Club, in the county of Abitibi-West, under the name of \"Cercle Agricole de la paroisse de Ste-Germaine \"in conformity with the Farmers\" Clubs Act (R.S.Q.1941, chap.118).Quebec, April 25, 1950.Le Sous-ministre de l'Agriculture, R.TREPANIER, 27373-0 R.TREPANIER.27373 Deputy Minister of Agriculture. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1257 Département de l'Instruction publique N° 588-50.Québec, le 14 avril 1 !);\")().Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Beauhamois, ville, dans le comté de Hcauharnois, en celui de \"Cité de Beauhamois,\" même comté.IvC Surintendant «le l'Instruction publique, 2728S-IG-2-0 O.1.DESAULNIERS.N° 31(5-49.Québec, le 17 avril 1950.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Macamic, dans le comté d'Abi-tibi-Ouest, le territoire ci-dessous décrit et de l'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de Paroisse de Macamic, savoir: Les lots suivants, tous inclusivement du canton «le Poularies: 1 à 49 «lu rang X.Dans le canton Royal Roussillon: I à 49 du rang I: 1 à 15 et 28 à 49 des rangs II et III; 1 à 49 des rangs IV et V; 1 à 48-A du rang VI; 1 à 28 du rang VI; Le Surintendant de l'Instruction publique, 27319-10-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 463-50.Québec, le 19 avril 1950.Demande est faite «le détacher de la municipalité scolaire de Sainte-Adélaïde de Pabos, dans le comté de (îaspé-Sud, les lots 63-A à 68-B et toutes leurs subdivisions et les annexer à la municipalité scolaire «le Chandler, dans le même comté.Le Surintendant «le l'Instruction publique, 27320-10-2-o O.-J.DESAULNIERS.N° 707-48.Québec, le 19 avril 1950.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire de Saint-Jean-de-Cherbourg, dans le comté de Matane des lots 38 à 49 inclusivement rangs X et XI du canton de Saint-Denis, qui ne sont pas encore organisés au point de vue scolaire; et les lots nos 43 à 49 inclusivement «les rungs VIII et IX du même canton, qui seront détachés de la municipalité scolaire de Saint-Adelmc, dans le comté «le Matane.Le Surintendant «le l'Instruction publique, 27321-16-2-0 O.-J.DESAULNIERS.N° 450-50.Québec, le 18 avril 1950.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Joachim, comté «le l'Assomption, les lots nos 329 et 330 du cadastre officiel «le Ste-Anne-des-Plaines, et de les annexer à la municipalité scolaire de Sainte-Anne-des-Plaines N° 2, comté «le Terrebonne.Le Surintendant «le l'Instruction publi«|ue.27322-16-2-0 O.-J.DESAULNIERS.N° 286-49.Québec, le 20 avril 1950.II a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date «lu 20 juillet 1949.«le détacher «le la municipalité scolaire de l'Ile Perrot, dans le comté de Vau-dreuil, le territoire ci-dessous décrit et «le l'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"L'Ile-Perrot-Nord'', dans le même comté, savoir: Department of Education No.588-50.Quebec, April 14, 1950.Application is imule to change the name of the school municipality «>f Beauhamois, town, in the county of Beauhamois, to that of \"City of Beauhamois, same county.O.J.DESAULNIERS, 272S8-16-2 Superintendent of Education.No.316-49.Québec, April 17, 1950.Application is made to detach from the school municipality of Macamic, in the county of Abi-tibi-West, the territory hereinbelow describe«l and to erect it into a separate school municipality, under the name of the Parish of Macamic, to wit: The following lots, all inclusive, of the township of Poularies: 1 to 49 of range X.In the township of Royal Roussillon: 1 to 49 of range I; 1 to 15 and 28 to 49 of ranges II and III; I to 49 of ranges IV and V; 1 to 48-A of range VI; 1 to 28 of range VI; O.J.DESAULNIERS, 27319-16-2 Superintendent of Education.No.463-50.Quebec, April 19, 1950.Application is made to detach from the school municipality of Sainte-Adélaïde de Pabos, in the county of Gaspé South, lots 63-A to 68-B and all the subdivisions thereof, and to annex them to the school municipality of Chandler, in the same county.O.J.DESAULNIERS, 27320-16-2 Superintendent of Education.No.707-48.Quebec, April 19, 1950.Application is made to annex to the school municipality of Saint-Jean-de-Cherbourg, in the county of Matane, lots 38 to 49 inclusive of ranges X and XI of the township of Saint-Denis, which are not as yet organizc«l as regards schools; ami lots Xos.43 to 49 inclusive of ranges VIII and IX of the same township, to be detached from the school municipality of Saint-Adelme, in the county of Matane.().J.DESAULNIERS, 27321-16-2 Superintendent of Education.No.450-50.Quebec.April 18, 1950.Application is made lo detach from the school municipality «>f Saint-Joachim, county of l'Assomption, lots Xos.329 and 330 of the official cadastre for Ste-Anne-tles-Plaines, and to annex them to the school municipality of Sainte-Anne-des-Plaines.No.2, countv t)f Terrebonne.O.J.\" DESAULNIERS.27322-16-2 Superintendent of Education.No.286-111.Quebec, April 20, 1950.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased by Order in Council dated July 20th.1949, to detach from the school municipality of l'Ile Perrot, in the county of Vau-dreuil, the territory hcrciniinder described and to erect it into a separate school municipality, under the name of \"LTIe-Perrot-Xonl\" in the same county, to wit: 1258 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 Partant d'un point situé sur la grève de la rivière Ottawa, dans la ligne de division entre les lots nos 184 et 189 et de là, en se dirigeant dans une direction sud-est, en suivant la ligne de division entre les lots nos 188 et 189 d'une part et le lot 184 d'autre part, jusqu'à son intersection avec la ligne de division entre les lots nos 184 et 185; de là, en se dirigeant vers le sud-ouest en suivant la ligne de division entre les lots nos 184 et 185 jusqu'à son intersection avec la ligne nord-est du lot no 183; de là, en se dirigeant vers le sud-est en suivant la ligne de division entre les lots nos 185 et 18G «l'une part et le lot no 183 d'autre part, jusqu'à l'extrémité sud-ouest du lot no 186; de là.en se dirigeant vers le nord-est, en suivant la ligne sud-est des lots nosl.86 et 187 jusqu'à son extrémité sud-est, de là, en se dirigeant vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division entre les lots nos 1S7 et 193, jusqu'à sa rencontre avec la ligne de division entre le> lots nos 191 et 193; de là.en se dirigeant vers le nord-est.en suivant la ligne sud-est, des lots nos 191 et 192, jusqu'à son extrémité sud-est; de là, en SC dirigeant vers le sud-est, en suivant la ligne de division entre les lois nos 203, 204, 205, 20(1, 207.209-Â, 210-A, 211.212.212-A, 212-B, 212-C et 213 «l'une pari et le lot No 193 d'autre part jusqu'à son intersection avec le lot N° 218-A; «le là, en se dirigeant vers le nord-est en suivant la ligne nord-ouest «lu lot N 218-A jusqu'à son extrémité nord-est; «le là.«mi se dirigeant vers le sud-est «mi suivant la ligne «le division entre les lots nos 210.217.218 et 219 «l'une part et le lt>t N° 218-A, d'autre part, jusqu'à son intersection avec le l«>t 220; «le là.en se dirigeant vers le sud, en suivant la ligne «le division entre les lots nos 220, 222, 221 et 225 d'une part et le l«>t N° 77 d'autre part, jusqu'à son intersection avec le lot N° 70; de là.en se dirigeant vers le nord-est.en suivant la ligne «!«\u2022 division entre les lots nos 225, 227, 229, 230.230, 237 «4 212 «l'une part et les lots nos 70, 75, 7-1 73, et 71 «l'autre part jusqu'à l'extrémité sud-est «lu lot N° 212; «le là, en se dirigeant vers le nord-est en suivant la ligne de division entres les lots 242 et 241 «l'une part et les lots nos 243 et 245 «l'autre part jusqu'à sa rencontre avec la grève «le la rivière Ottawa; de là.se dirigeant dans une direction générale ouest, et nord-ouest en suivant la grève de la rivière Ottawa jusqu'au point «le départ.Ce territoire comprend aussi les Iles portant les numéros 325 à 34(5 inclusivement dudlt cadastre; lequel territoire, ensemble avec tous les chemins, rues, ruelles, emprises «le chemins «le fer, rivières, lacs, cours «l'eau ou partie d'iceux compris dans les limites ci-dessus «lécrites.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1950.Le Surinteiulant «le l'Instruction publique, 27343-0 OMER-JULES DESAULNIERS.N° 1403-49.Québec, le 15 avril 1950.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date «lu 19 avril I960, «l'annexer à la municipalité scolaire protestante «le Saint-André-Est, dans le comté d'Argenteuil, le territoire its northeast extremity; thence, running southeasterly, following the division line between lots Nos.210.217, 218 and 210 on the one part ami lot No.21S-A on the other part up to its intersection with l«>t No.220; thence, running southerly, following the division line between lots Nos.220, 222.224 and 225 on the one part and lot No.77 on the other part, up to its intersection with lot No.70; thence, running northeasterly, following the division line between lots No.225, 227.229, 230.230, 237 and 242 on the one part and lots Nos.70.75, 74.73 and 71 on the other part, up to the southeast extremity of lot No.242; thence, running northeasterly, following the division line between lots Nos.242 and 241 on the one part, ami lots Nos.243 and 245 on the other part, up to its meeting with the bank of the river Ottawa: thence, running in a general westerly ami northwesterly direction, following the bank «>f the river Ottawa up to the starting point.Said territory also comprises the islands bearing numbers 325 to 340 inclusively of said cadastre; said territory, together with tin- roads, streets, lanes, railway rights of way.rivers, lakes, water-courses or parts thereof comprised within the above-described limits.This Order in Council shall come into force «>n the first of July, 1950.OMER JULES DESAULNIERS, 27343 Superintendent of Education.No.1403-49 Quebec.April 25.1950.Iiis Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated April 19.1950, to annex to the Protestant School municipality of Saint-André-East, in the county of Argenteuil, the territory of the school municipality of Pointe-Fortune, in the County of Vau-dreuil, applicable to Protestant tax-payers only, t«> wit : Lots 1 to 112 inclusively of the Municipality of Pointe-Fortune, and shall be bounded as follows, to wit: on the west by the division line of the Provinces «>f Quebec and Ontario; on the north east by the middle of the Ottawa River; on the southeast by the division line between lots 1 ami QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1259 Pointe-Fortune et 5S0 et 5S1 de Ste-Madeleine-de-Ligaud; au sud-ouest, par le rang Saint -Thomas-Nord de la municipalité de Sainte-.VLa-deleine-de-ltigaud.Le Surintendant de l'Instruction publique, 273S9-o t).J.DESAlhuNiEltS.n° 644-49 Québec, le 26 avril 1950.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, le territoire ci-dessous décrit et de l'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"Paroisse de Saint-Eustache\", même comté.Ce territoire est borné comme suit, savoir: Partant du point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière .Jésus, avec la ligne de division entre les paroisses de St-EllStache et «le Ste-Thérèsc, la ligne limitative prend une direction nord-ouest, sud-ouest*.nord-ouest, nord et \u2022nord-ouest c'est-à-dire suit la ligne de division entre lesdites paroisses de St-Eustachc et de Ste-Tliérèsc jusqu'à l'intersection de cette ligue avec-la limite de la paroisse de St-Augustin; de là.la ligne limitative prend une direction sud, puis ouest, nord, ouest, sud-ouest, nord-ouest, ouest, sud, ouest, sud.sud-ouest puis ouest, c'est-à-dire qu'elle suit tous les méandres de la ligne de division entre la paroisse de Saiiit-Kustache et la paroisse «le Saint-Augustin jusqu'à l'intersection «le cette ligne avec la limite de la paroisse de St-Bc-noit; «le là.la ligue limitative prend une direction sud et suit la ligne «le division entre la paroisse de Saint-Eustache et la paroisse «le St-Bcnott, jusqu'à son intersection avec la limit*' «le la paroisse de Saint-Joseph; «le là, la ligue limitative prend une direction sud-est et suit la ligne «le division entre la paroisse «le St-Eustache et la paroisse de Saint-Joseph jusqu'à son intersection avec le lac des Deux-Montagnes; «le là.la ligne limitative prent! une direction nord-est et suit la ligne «les hautes eaux du lac des Deux-Montagnes jusqu'à son intersection avec la ligne de division entre les lots nos 121 et 124; «le là, la ligne limitative prend une «lirection nord-ouest et suit la ligne de «livi-sion entre lesdits nos 121 et 124 et se prolonge en ligne droite jusqu'au côté nord-ouest «lu chemin du lac; de là, la ligne limitative prend une direction sud-ouest et suit le «-ôté.nord-OUCSt «lu chemin du lac, jusqu'à son intersection avec la ligne de division entre les lots nos 122 et 123; «le là, la ligne limitative prend une direction nord-ouest et suit la ligne «le division entre lesdits lots 122 et 123 jusqu'à la limite nord-ouest de ces lots; de là, la ligne limitative prend une «lirection sud-est et autres, c'est-à-dire qu'elle suit la ligne séparant, la concession «le la côte «lu Lac et la concession du Sud de la Petite-Rivière jusqu'à la ligne «le division entre les lots nos 53 et 277; «le là, la ligne limitative prend une «lirection nor«l-oucst et suit la ligne de division entre les lots nos 53 et 277 jusqu'à la ligne limite de la municipalité «lu village de Saint-Eustache Sur-le-Lac; «le là, la ligne limitative prend une direction nord-est, traverse le lot no 53 jusqu'à la ligne «le division entre ledit no 53 et le lot no 52; de là, la ligne limitative prend une «lirection nord-ouest et suit la ligne de division,entre lesdits lots nos 52 et 53 jusqu'au centre de la rivière du Chêne; de là, la ligne limitative prend une direction est et suit le centre de ladite rivière jusqu'à la ligne de division entre les lots nos 2S9 et 288 d'un côté et le lot no 2S0 et la limite «le la ville «le St-Eustache de l'autre côté; de là.la ligne limitative prend une «lirection nord-ouest et suit cette dernière ligne «le «livision jus- 97 of Pointe-Fortune, and 5^0 and 581 of Ste-Madeleine-de-Rigau.l; on the southwest by range Saint Thornxs North, of the municipality of Saintc-Maxlelcine-«L'-ltigau:l.o.7.d:«:sauln[ers, 27339 Superintendent of e«lucition.No.644-49.Quebec, April 26, 1950.Application is made to detach from the school municipality of Saint-Eustache, county of Two Mountains, the f«>Ilowing territory described below and to erect it into a separate school municipality umler the name of \"Parish of Saint-Eustache\", same county.The said territory is bounded as follows, to wit: Starting from the point of intersection of the high-water mark of the Jésus river with the division line between the parishes of St-Eustachc and Ste-Thérèse, the limit line takes a «lirection northwest, southwest, northwest, north and northwest that is to say it follows the «livision line between the said parishes of St-Euslache ami Ste-Thérèsc as far as the intersection of the said line with the limit of the parish of St-Augustin: thence, the limit line takes a «lirection south, west, north, west, southwest, northwest, west, south, west, south, southwest and west, that it to say it follows all the mcanderings of the division line between the parish of Saint-Eustache and the parish «if Saint-Augustin up to the intersection of the said line with the limit line of the parish «>f St-Benoit; thence, the limit line lakes a direction south and follows the division line between the parish of Saint-Eustache and the parish of St-Benoit, up to its intersection with the limit of the parish of Saint-Joseph; thence, the limit line takes a «lirection southeast and follows the division line between the parish of St-Kustache and the parish of Saint-Joseph as far as its intersection with the Uikc of Two Mountains; thence the limit line takes a northeasterly directum ami follows the high-water line «>f the Like of Two Mountains to its intersection with the division line between lots Nos 121 and 124; thence the limit line takes a northwesterly direction and foll«>ws the «livision line between the said Nos.121 and 124 and extends in a straight line up to the northwest side of the lake road; thence, the limit line takes a southwesterly direction ami follows the northwest side of the lake roa«l to its intersection with the division line !>etwcen lots Nos.122 and 123; thence the limit line takes a northwesterly direction and follows the «livision line l>etween said lots 122 and 123 as far as the northwest limit of sai«l lots; thence, the limit line takes a southeasterly «lirection ami other «lirections, that is to say it follows the line separating the concession of the lakeside (côté «lu lac) and the South concession «>f the \"Petite Rivière\" up to the division line between lots Nos 53 and 277; thence, the limit line takes a northwesterly direction ami follows the «livision line between lots Nos 53 and 277 as far as the limit line of the municipality of the village of Saint-Eustache Sur-lc-Lac; thence, the limit line takes a northeasterly «lirection, crosses lot No.53 up to the division line between said lot No.53 ami lot No.52; thence, the limit line takes a northwesterly «lirection and follows the «livision line between said lots Nos.52 and 53 up to the mid«lle of the \"du Chêne\" river; thence, the limit line takes an easterly «lirection and follows the middle of the said river t«> the division line between lots Nos.289 ami 288 on one side and lot No.280 and the 1200 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 09 avril 1950, Tonte 82, N° 17 qu'à un point situé ù distance de seize cents pieds anglais du chemin public; de là, la ligne limitative prend une «lirection nord-est et traverse les lots 285, la route nationale, les lots nos 284, 283, 2S1 et 280 jusqu'à la ligne de «livision entre les lots nos 270 et 280 et frappe cette ligne à un point situé à dix-neuf cent cinquante pieds anglais au nord-ouest «lu côté nord-ouest de la nouvelle route nationale, c'est-à-dire que la ligne limitative suit la limite nord-ouest de la ville de St-Eustache; de là, la ligne limitative prend une direction sud-est et suit la ligne de division entre les lots nos 279 et 2S0 sur une hmgucur de dix-huit cents pieds anglais de là, la ligne limitative prend une, direction nord-est et traverse les lots nos 279, 278 50 et 48 jusqu'à la ligne de division entre les lots nos 47 et 48 à un point situé à une distance «le seize cent soixante pieds anglais du chemin «le la Grande Côte; de là, la ligne limitative prend une direction sud-est et suit la ligne de division entre les lots nos 47 et 48 jusqu'à la rivière Jésus; de là, la ligne limitative prend une direction nord-est et suit la ligne des hautes eaux de la rivière Jésus jusqu'au point de départ.Le Surintendant de l'Instruction publique, 273S7-17-2-0 O.J.DESAULNIERS.limit of the town of St.Mustache on the other side; thence, the limit takes a northwesterly direction and follows this last division line up to a point situate at a distance of sixteen hundred feet, English measure, from the public road; thence, the limit line takes a northeasterly «lirection and crosses lot 2S5, the national highway, lots Nos.284, 2S3, 2SI and 280 up to the division line between lots Nos.279 ami 2S0 and hits the said line at a point situate at nineteen hundred ami fifty feet, English measure, northwest of the northwest side of the new national highway, that is to say that the limit line follows the northwest limit of the town of St-Eustache; thence, the limit line takes a southeasterly «lirection ami follows the «livision line between lots Nos.279 and 2S0 for a distance of eighteen hundred feet, English measure, thence, the limit line takes a northeasterly direction and crosses lots Nos.279, 278, 50 and 48 as far as the division line between lots Nos.47 and 48 at a point situate at a distance of sixteen hundred and sixty feet, English measure, from the ro'ad of the big hill \"Grande Côte\";thence, the limit line takes a southeasterly direction and follows the division line between lots 17 and -18 up to the Jésus river; thence, the limit line takes a northeasterly direction and follows the high-water line of the Jésus river up to the starting point.O.J.DESAULNIERS, 27387-17-2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel «le la paroisse «le Notre-Dame «le Québec «livision d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné qu'une partie «les lots 41-A-105 et ll-A-112 est annulée en vertu «le l'article 2174A «lu Code civil.Québec.le 31 mars 1950.Le Déparlement «les Terres et Forêts, Service «lu Cadastre, Ix* Sous-ministre.27360-o A VILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel «lu canton «le Morili Division «l'en régi st re m e n t « 1 ' A r gen ten i I.Avis est par la présente donné «pie dans le Rang II les lots 3SA-1, 3SA-4 à 38A-19.38A-24 à 38A-40, 3SA-5I à 3SA-50, 38A-5S à 3SA-88.38A-90 à 38A-92, 38A-99 à 38A-102, 38A-U1, 3SA-1I2.partie «les lots 38A-57, 3SA-89.3SA-90 et 38A-97 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 avril 1950.Le Département des Terres et Forêts, Service «lu Cadastre, Le Sous-ministre, 27365-o A VILA BÉDARD.AVIS Cadastre revisé «le la f the Executive Council and by Commission, t«> make the billowing appointments: Quebec, March 2, 1950.Mr.Grégoire Poulin, advocate and licensed accountant.i du Rule of Court Province of Quebec, «listrict «>f Joliette, Ma-gist rate's Court, No.14,889.REN É TELLIER, plaintiff; vs PIERRE LEFEBVRE, defendant; & LEONCE MI VILLE, opposant.( !all to the Creditors of the Dependant The creditors of Mr.Pierre Lefebvre, farmer, of the parish of St-Cléophas de Brandon, «listrict of Joliette are called upon to file their claims, with vouchers attached, within fifteen days following the date of the first insertion of these presents.?.t the office of the Superior Court, at Joliette, with the clerk of the said Court, the whole in accordance with articles 673 and 674 of the C.C.P.By onlcr of the Honourable Justice François Caron, dated April 5.1950.Joliette, April 17, 1950.ALLARD & JOLY.Prothonotary of the Supermr Court 2729S-10-2 for the District of Joliette.Proclamations Canada, Province «>r BUG.FISBT Quebec.[I, S.] GEORGE VI.by the Grace of God.of Great Britain.Ireland and the British Dominions beyond the Seas, King.Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Gueetinf the towtishh) Courcellcs, comprising a part of Ranges I to XII.the Ranges southwest au 1 Northeast of Desautcls road, the Range Northeast of Lac des Iles and the Ranges southwest and northeast of the Mastigouchc River.e) Registration division of Papineau.Part of the township Preston, comprising apart of Ranges I to IX ami the Islands Nos.1, 2 and 3./) Registration division of Lab M J.Part of the township Labelle, comprising a part of Ranges A, B, C, L V to XI, Block A.several Islands in different lakes.g) Registration division of Abitibi.Part of the township McKen/.ie, comprising Bl«>cks D and E.//) R -giitration division of Troii-Rioièrjl.Part of the township Desaulnicrs, comprising Ranges I ami II.Blocks A, B, C, D an 1 F and the Islands Nos 1 to 44.Whereas all the said plans and books of reference now remain of record in the archives of the Department of Land and Forests and that an exact copy has been filed in the «)ffice of the Registration «livision concerned; Whereas under the provisions of Article 2109 of the Civil Code, it is now expedient to announce, by a proclamation of the Lieutenant-Governor in ( ïouncil, the deposit of the said plans and books of reference and to fix.at the same time, the date upon which the provisions of Article 2168 of the Civil Cole will come into f«>r«-e for each of the parts of townships above described; Therefore, with I'\"' advice and consent «>f Our Exechtive Council, expressed in an order dated the 6th of -April.1950,- bearing No.340.We give notice of the filing of the said plans and books of reference for each of the parts of townships above described and We fix the; late of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gaz tic, th.- f forfeiture of the priority conferred by the Civil Code, to renew, with the two years following the date fixed as aforesaid, the registration of all real rights on a lot «>f land comprised within one of the parts of the said townships and in their respective registration division.Ok am, of which our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly. 1264 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, No.17 En roi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur ieelles apposer le grand sceau de Notre province «le Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aiiné Le Major-général l'honorable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt.C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-Gouverneur de Notre dite province de Quelle.Donné en Notre hôtel «lu gouvernement, en Notre cité «le Quebec, de Notre province «le Québec, ce .sixième jour d'avril en l'année mil neuf cent cinquante de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatorzième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire «le la Province.27371-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de EUG.FISET Québec.|L.S.] GEORGE V, par la grâce «le Dieu, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà «les mers, défenseur «le lu \"foi.A tous ceux «pli ces présentes lettres verront ou qu'icclles pourront concerner.Salut.PROCLAMATION V'Assistant-procureur i A TTENDU que leçon-générul, \\ soil «le la munici- L.DÉSILETS.' palité de St-Simon de Drummond, a soumis pour approbation son règlement numéro 43 à reflet de soumettre le territoire de la municipalité à lu juridiction de la Cour du recorder f Our Province of Quebec, t«» be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major General, the Honourable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt., C.M.G., D.S.().M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House in Our City «>f Quebec, in Our Province «>f Quebec, this sixth day of April, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty ami the fourteenth year «>f Our Reign.Bv command.JEAN BRI (TI ESI, 27374 Under Secretary «>f the Province.Canada.Province of EUG.FISET Quebec.|L.8.1 GEORGE VI.by the Grace «»f God, ol Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the seas, King.Defender of the Faith, To all to whom these presents shall COU1C or whom the same may concern, GllRETINU.PROCLAMATION L.désilets, j V\\7HEREAS the Council of Deputy Attorney < W the municipality of St-Gencral.v Simon do Drummond, county of Drummond, has presented for approval, its By-law number 43, to the elect of submitting the territory of the .Municipality to the jurisdiction of the Recorder's ( lourt, «>f the City of Drummondville; Whereas, the Council of the City of Drummondville, by its by-law number 366, has agreed with the tenor of the said By-law of the Council of the Municipality of St-Simon-de-Drummond; WHEREAS these by-laws were approved in conformity with the Law and that all formalities prescribed have been fulfilled; Therefore, with the advice and cousent of Our Executive Council expressed in an Order of April 0, 1950, bearing No.259, and pursuant to the provisions of sections G93 to 69i inclusively of the ( ities and Towns Act (Revised Statutes, 1941, chapter '£.>','>) and of sections '\u2022> to 7 inclusively of the Recorder's Courts Act, (Revised Statutes, 1941, chapter 17) We have enacted and do order that from and after thirty-one days following the date of the publication of the present Proclamation, the territory of the Municipality of St-Simon dc Drummond, county-of Drummond, shall be subject to the jurisdiction of the Recorder's Court, established in the city of Drummondville, as if the two municipalities formed but one, but for such purpose only.Ok add ok which our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major-General, the Honourable Sir EUGENE- QUEBEC OFF ICI AL GAZETTE, Quebec, April 29th, 1950, Vol.82, No.17 1205 JOSEPH FISET, Kt., C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-gouverneur de Notre dite province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce sixième jour d'avril en l'année mil neuf cent cinquante de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatorzième année.Far ordre, I/O Sous-secrétaire de la Province, 27374-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de EUG.FISET Québec.[L.S.] GEORGE VI, par la grâce de Dieu, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'ieellcs pourront concerner, Salut.PROCLAMATION L*Assistant-procureur i A TTENDU que l'arti-général, \\ -**-e!c (i de la loi 1-1 George L.D/.8ilet8.' VI.chapitre 120, intitulée \"Loi érigeant la municipalité de Saint-Simon-lcs-Mines, dans le comté de Beauce\", décrète (pic ladite loi entrera en vigueur à la date qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation; Attendu qu'il y a maintenant lieu de fixer au premier juin 1950 la date de l'entrée en vigueur de cette loi; A ces causes, de l'avis et du consentement de Notre Conseil exécutif, exprimés dans l'arrêté en conseil numéro 417.du 19 avril 1950, et conformément aux dispositions de l'article 0 de la Loi érigeant la municipalité deSaint-Simon-lcs-Mines, dans le comté de Beauce (14 George VI, chapitre 126), Nods avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que la date de l'entrée en vigueur de la loi 14 (îeorge VI, chapitre 120, intitulée \"Loi érigeant la municipalité de Saint-Simon-lcs-Mines, dans le comté de Beauce\", soit fixée au premier juin 1950.De tout ce que dessus, tous Nos féaux-sujets et tous autres (pie les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de\" se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur ieelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé le Major-général l'honorable Sir EUGÈNE-MARI E-JOSEPH FISET.Kt., C.M.G., D.S.O., M.D.Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-neuvième jour, d'avril en l'année mil neuf cent cinquante de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatorzième année.Par ordre, Le sous-secrétaire de la Province, 27374-0 JEAN BRUCHÉSI.MARIE-JOSEPH FISET, Kt.C.M.G., D.S.()., M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this sixth day of April, in the year of Our Lord nineteen hundred ami fifty and the fourteenth year of Our Reign.By command.JEAN BRUCHÉSI, 27\">71 Undersecretary of the Province.Canada, Province of EUG.FIS FT Quebec.[L.S.] GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas.King, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.PROCLAMATION L.D tel lets, (\"VXTHFRFAS section 0 of the Deputy Attorney < Act 14 George VI, General.(chapter 121), intituled \"An Act to erect the Municipality of Saint-Simon-lcs-Mines in the county of Beauce\".enacts that the said Act will come into force on such date as it may please the Lieutenant-Governor in Council to fix by Proclamation; WlIEREAS it is now expedient to fix to the first day of June 1950, the date of the coming into force of the said Act, THEREFORE, with the advice ami consent of Our Executive Council, expressed in Order in Council number 417, of April 19, 1950.and in conformity with the provisions of section 6 of the Act to erect the Municipality of Saint-Simon-lcs-Mines, in the county of Beauce.(14 George VI, chapter 120) We have enacted and ordered and do hereby enact and order, that the date of the, coming into force of the Act 14 George VI chapter 126, intituled \"An Act to erect the Municipality of Saint-Simon-lcs-Mines, in the county of Beauce\" be fixed to the first of June, 1950.' Of all of which our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent ami the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major-General, the Honourable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, KI.CM.G.D.S.O., M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of April, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty and the fourteenth year of our Reign.Bv command.JEAN BRUCHÉSI.27374 Under Secretary of the Province. 1200 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril 1950, Tome 82, N° 17 Canada, Province de BUG.FISET Québec.[L.S.] GEORGE VI, par la grâce de Dieu, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, défenseur de la foi.a tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut.PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU que le con-gènéral, ) soil de la munici- L.DÉsiLBTS.\\ palité de Saint-Jean-Bap-' liste, comté de l^rum-moml, a soumis pour approbation son règlement numéro 322, à l'effet de soumettre le territoire de la municipalité à la juridiction de la Cbur du recorder de la cité de Drummondville; Attendu que le conseil de la cité «le Drummondville, par son règlement N° 365, a concouru dans la teneur de ce règlement du conseil de la municipalité «le Saint-Jean-Baptistc; attendu que ces règlements ont été approuvés conformément à la loi et «pie toutes les formalités prescrites ont été remplies.En conséquence, de l'avis et «lu consentement «le Notre Conseil exj'-eutif, exprimés dans un décret du G,avril 1950, portant le N° 359, et vu les dispositions des articles 093 à 097 inclusivement de la Loi «les cités et villes (Statuts refondus, 1911, chapitre 233), et «les articles 3 à 7 inclusivement «le la Loi «les Cours de recorder (Statuts refondus, 1941, chapitre 17), Nous avons décrété et décrétons qu'à compter «le trente et un jours après la date «le la publication de la présente proclamation, le territoire de la municipalité de Saint-.f.ean-Baptiste, comté «le Drummond, sera .soumis à la juridiction de la Cour du recorder établie dans la cité de Drummondville, comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres «pie les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur ieelles apposer le grand sceau de Notre province «le Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé le Major-général l'honorable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt., C.M.G., D.S.O.M.D., Lieutenant-gouverneur «le Notre dite province de Québec.Donné en Notre hôtel «lu gouvernement, en Notre cité «le Québec, «le Notre province «le Québec, ce sixième jour d'avril en l'année mil neuf cent cinquante «le l'ère chrétienne et de Notre Rè'ïne la quatorzième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 27374-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province of EUG.FISET Quebec.[L.S.j GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, King.Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting.PROCLAMATION L.DÉsiLETs.(VWIIEREAS the council of Deputy Attorney) VV the municipality of General.j Saint-Jean-Baptiste, county of I Drummond.has submitted for approval its By-law No.322, with a view to submitting the territory of the municipality to the jurisdiction of the Recorder's Court of the city of Drummondville; Whereas the council of the city of Drummondville, by its By-law No.305, agrees with the tenor of the said by-law of the council of the municipality of Saint-Jean-Baptistc; Whereas the said by-laws were approved in conformity with the Law and all the formalités have been fulfilled.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in an order dated the 6th of April, 1950, bearing No.359, and in view «>f the provisions of sections 693 to 097 inclusive of the Cities an«l Towns Act (Revised Statutes, 1911, chapter 233), and sections 3 to 7 inclusive of the Recorder's Courts Act (Revised Statutes 1941, chapter 17), We have enacted and do enact that from and after thirty-one days, after the publication of the present proclamation, the territory of the municipality of Saint-Jean-Baptistc, county of Drummond, will be submitted to the jurisdiction of the Recorder's Court established in the city of Drummondville, as if the two municipalities formed but one but for such purpose only.Of all of which Our loving subjects and all others whom these'presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereuntt) affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major General, the Honourable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET.Kt.C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this sixth ar les présentes transporté de la Cité de Hull à la Cité «!«' Montréal, province de Québec.\" Extrait certifié conforme.Montréal, ce 1er avril 1950.I.a Secrétaire, i Signé) Sr M.GENEVIEVE DE L'EUCH.(Sceau) 27345-o ment of the corporation, 12036.Boulevard L'Archevêque, Montreal, on April I, 1950, respecting the moving of the head office of the said corporation from the City of Hull to the City «»f Montréal.By-Law No.\"A\" \"Whereas, in virtue of letters patent incorporating the corporation*under Part III of the Quebec Companies Act, issued under date of January 17, 1928, and registered on January 18, 192S, the head office of the corporation was established at Hull, district of Hull, Province of Quebec.Whereas it is deemed desirable to transfer the head office «>f the company from Hull t«) Montreal, «listrict of Montreal, Province of Quebec.Therefore, \"La Corporation des Religieuses «les Cinq Plaies\" through its Directors, enacts that the head office of the corporation be and it is hereby moved from the City of Hull, to the City of Montreal, Province of Quebec.\" (Vilified True Copy.Montréal, April 1, 1950.(Signed) Sr M.GENEVIEVE DE L'EUCH, Secretary.(Seal) 27345 Avis de siège social Avis est par la présente donné que \"be Laboratoire Octo Ltée\u2014Octo Laboratory Ltd,\" constitué en corporation par lettres patentes «lu 30 mars 1950, a établi son siège social à 8725, rue Lajeunesse, Montréal.L'avocat, 2735C-0 PHILIPPE PERLA NI).Montreal Institute ok Investment Analysts Avis «le la situation «lu bureau principal Avis est donné que \"Montreal Institute of Investment Analysts.\" constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la troisième partie «le la Loi «les compagnies de Québec en date «lu 8 mars.1950, et ayant son bureau principal dans la cité «le Montréal, a établi son bureau au numéro 680, ouest, rue Sherbrooke, Montréal 2.A compter «le la date du présent avis, ledit bureau est considéré par ladite corporation comme étant son bureau principal.Dorme à Montréal ce 24e jour d'avril.1950.l.e Secrétaire, 27357-«.JOHN GIBSON.Avis de la situation du bureau principal de la «\u2022ompagnie \"General Sea Products (Quebec) Limited\".Avis est donné par les présentes «pie la compagnie \"General Sea Products (Quebec) Limited\", constituée en corporation eu vertu «le la Première Partie «le la Loi des Compagnies «le Québec, Statuts Revisés de Québec, Chapitre 27(5, par lettres patentes «latées du 18 février 1949, enregistrées le 3 mars 1949.Libro 209.Folio 184, et ayant son bureau à 57 ouest, rue St-Jactpies, dans les Cité et District de Montréal.Notice of Head Office Notice is hereby given that \"I* Laboratoire Octo Ltée\u2014Octo Laboratory Ltd.\", incorporate by letters patent under date of March 30, 1950, has established its hea«l t>ffice at 8725, La jeunesse Street.Montréal.PHILIPPE FERLAND, 27350-O lawyer.Montreal Institute of Investment Analysts Notice of Situation of Head Office Notice is hereby given that \"Montreal Institute of Investment Analysts\", incorp«)rated by Letters Patent under Part III of the Quebec Companies Act on the 8th day of March, 1950, ami having its Head Office in Montreal, has established its «jffice at 680 Sherbr«)oke Street, West, Montreal 2.From and after the date of this notice the said office shall be consi«Iere«l by the Institute as being its head office, Dated at Montreal this 24th day of April, 1950.JOHN GIBSON, 27357-o Secretary.Notice of sit nation of Head Office of the Company \"General Sea Products (Quebec) Limited\".Notice is hereby given that the company \"General Sea Protlucts (Quebec) limited\", incorporated under Part 1 of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec 276, by letters patent dated February IS, 1949, registered on March 3, 1949, Libro 209.Folio 184, ami having its head office in the city of Montreal, has established its office at 57 St.James Street West, in the city and «listrict of Montreal. 1268 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, $9 avril 1950, Tome 82, N° 17 A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Montréal, le (i avril 1950.(Sceau) General Sea Products (Quebec) Limited.Le Président, 27381-0 RAOUL ROBERT.Prom and after the date of the present notice, the*.said of lice will be considered by the company as being its head-office.Montreal, April (i, I960.(Seal) General Sea Products (Quebec) Limited.RAOUL ROBERT, 27381 President.Soumissions AVIS Bureau des Commissaires d'Ecoles Catholiques Romains de la Citï: de Sherbrooke Avis public est par les présentes donné, que des soumissions cachetées et endossées: \"Soumissions pour obligations\", seront reçues par le soussigné, Majella Vigncault, secrétaire-trésorier, 75, King Ouest, Sherbrooke, jusqu'à trois heures de l'après-midi, le 15 mai* 1050, 'pour l'achat d'une émission d'obligations au montant de §350,000.00 du Bureau des Commissaires d'Ecoles Catholiques Romains de la ( 'ité de Sherbrooke', et remboursables en séries du 1er mai 1051 au 1er mai 1970 inclusivement.Les soumissions pourront être faites pour des obligations portant intérêt à un taux n'excédant pas 3b->% et le taux offert pourra être le même pour toute l'émission où il pourra varier selon les échéances.L'intérêt sera payable semi-an-nuellement les premier mai et premier novembre de chaque année.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom apparaît dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Sherbrooke.Les dites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus «le Québec 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Ces obligations seront datées du premier mai 1950 et remboursables en série comme suit: Année Capital 1951.§12,500.00 1952 .13,000.00 1953 .13.500.00 1954 .14,000.00 1955 .14.000.00 1956 .14.500.00 1957 .15.000.00 195S.15.500.00 1959 .10,500.00 1960 .17.000.00 1961.17.500.00 1962 .bS.OOO.OO 1963 .18,500.00 1964.19.500.00 1965 .20,000.00 I960 .20,500.00 1967 .21.500.00 1968 .22.000.00 1969 .23,000.00 1970 .24,000.00 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté, fait à l'ordre du Bureau des Commissaires d'Kcoles Catholiques Romains «le la Cité de Sherhmokc et égal à \\°/( «lu montant Tenders NOTICE Board of the Roman Catholic Sr in part, at par.under authority of Chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec 1941, on any interest payment date; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called in reverse order of maturity ami serial number.The said bonds will be dated May 1st, 1950.an«l be r«'deemable serially as follows: Year Capital 1951.§12,500.00 1952 .13.000.00 1953 .13.500.00 1954 .14,000 00 1955 .14.000.00 1950 .14,500.00 1957 .15,000.00 1958 .15,500.00 1959 .16,500.00 1960 .17,000.00 19(il.17,500.00 1962 .18,000.00 1963 .18,500.00 1964 .19,500.00 1965 .20.000.00 1966 .20.500.00 1907 .21,500.00 1968 .22.000.00 1909 .23,000.00 1970 .24.000 00 Ea«'h tender must be accompanied by a certified cheque to the order of the Board of Roman Catholic Selmol Commissioners of the City of Sherbrooke, equal to 1% of the total amount of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 89th, 1000, Vol.88, No.17 1269 total de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus, sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et prises en considération à une session spéciak\\dudit bureau, session qui sera tenue à trois heures de l'après-midi, lundi le 15 mai a.m.1950 au bureau des Commissaires d'écoles, 75 King Ouest, Sherbrooke.Le Bureau des Commissaires d'Ecoles Catholiques Humains se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Donné à Sherbrooke, ce 29ièinc jour d'avril 1950.Le Secrétaire-trésorier, MAJELLA VIGNEAULT.27358-0 75, King Ouest, Sherbrooke.the loan and must sgecify whether the price offered includes or not accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and taken into consideration at a special meeting of the said Board, at 75 King Street West.Sherbrooke, to be held at three o'clock in the afternoon, Monday, the 15th day of May, 1950.The Board of Roman Catholic School Commissioners of the City of Sherbrooke does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Given at Sherbrooke, this 29th dav of April, 1950.1 MAJELLA VIGNEAULT, Secretary-Treasurer.27358-0 75 King Street West, Sherbrooke Province de Québec Municipalité de St-Jean-Baptiste (Comté de Drummond) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Jacques Bcaudoin, secrétaire-trésorier, 175, nie St-Damase.St-Jean-Baptiste, comté de Drummond, jusqu'à S heures p.m., lundi, le 15 mai 1950.pour l'achat de SI-10,000 d'obligations de la municipalité de St-Jean-Baptiste, datées du 1er juin 1950 et remboursables par séries du 1er juin 1951 au 1er juin 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas Z%% Par année, payable semi-annucllement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.L'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant : Province of Quebec Municipality ok St-Jean-Baptiste (County of Drummond) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Jacques Beaudoin, secretary-treasurer, 175 St-Damasc street, St-Jean-Baptiste, county of Drummond, up to 8 o'clock p.m., Mondav, the 15th day of May, 1950, for the purchase of S140.000 of bonds of the municipality of St-Jean-Baptiste, dated the 1st of June, 1950, and redeemable serially from the 1st of June, 1951, to the 1st of June, 1970, inclusive, with interest at a rate not exceeding 3]^% per annum, payable semi-annually the 1st of June and 1st of December of each year.Interest may be the same for the total issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 SI 10,000 \u2014 15 ans Année Capital 1er juin 1951.S5.000.00 1er juin 1952 .5,000.00 1er juin 1953 .5.500.00 1er juin 1954 .5,500.00 1er juin 1955 .5,500.00 1er juin 1956 .0.000.00 1er juin 1957 .0.000.00 1er juin 190S.0,500.00 1er juin 1959 .6.500.00 1er juin 1960 .6,500.00 1er juin 1.961.7,000.00 .1er juin 1962 .7.000.00 1er juin 1963 .7,500.00 1er juin 1904 .8.000.00 1er juin 19(55 .8.000.00 1er juin 100(5 .8,500.00 1er juin 1007 .8,500.00 1er juin 19(58 .9.000.00 1er juin 19(59 .9.000.00 1er juin 1970 .9.500 00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Ville St-Joseph, comté de Drummond.Les obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec.1941.être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant; si tel rachat est partiel, il affectera tes échéances les plus éloignées et les numéros les plus ('levés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à \\% du montant total Table of Redemption \u2014 SI40.000 \u2014 15 years Year Capital 1st June 1951.S5.000.00 1st June 1952 .5,000.00 1st June 1953 .5,500.00 1st June 1954 .5,500.00 1st June 1955 .5,500.00 1st June 1956 .6,000.00 1st June 1957 .6,000.00 1st June 1958 .6.500.00 1st June 1959 .6,500.00 1st June I960 .6,500.00 1st June 1961.7,000.00 1st June 1962 .7,000.00 1st June 1963 .' 7,500.00 1st June 1964 .S.000.00 1st June 1965 .8,000.00 1st June 1966 .S.500.00 1st June 19(57 .8,500.00 1st June 19(58 .9,000.00 1st June 1969 .9,000.00 1st June 1970 .9,500.00 Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at the Town of St-Joseph.county of Drummond.The bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest payment date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec.1941: however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amount of 1270 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 29 avril I960, Tome 82, N° 17 de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert the loan and must specify whether the price comprend uu ne comprend pas les intérêts accrus offered includes or does not include accrued int- sur les obligations au moment de leur livraison, crest on the bonds to time of their delivery.Les soumissions seront ouvertes et considérées Tenders will be opened and considered at a à une séance du conseil qui sera tenue lundi le meeting of the council to be held on Monday the 15 mai 1950, à 8 heures p.m.à la salle de l'École 15th of May, 1950, at 8 o'clock p.m., in the de St-Jean-Baptiste.St-Jean Baptiste School hall.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni The council docs not bind itself to accept the la plus haute ni aucune des soumissions.highest nor any of the tenders.St-Jean-Baptiste, comté de Drummond, ce St-Jean-Baptiste, county of Drummond, this ISème jour d'avril 1950.18th dav of April, 1950.Le Secrétaire-trésorier, JACQUES BEAUDOIN, JACQUES BEAUDOIN, Secretary-Treasurer, 175, rue St-Damase, 175 St-Damasc Street, 27346-0 St-Jean-Baptiste (Drummond), P.Q.27340 St-Jean-Baptiste (Drummond), P.Q.Province de Québec Province of Quebec Pahoisse St-Joseiui-oe-Souel, Pakisii ok St.Joseph de Sorbl (Comté de Richelieu) (County of Richelieu) Avis public est, par les présentes, donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné'.Gaston Laforest, secrétaire-trésorier, à son bureau, à 9 rue Désiré, St-Joseph-de-Sorel, comté de Richelieu, jusqu'à S heures p.m., le 22 mai 1950, pour l'achat de $275,000 d'obligations île la paroisse do St-Joscph-dc-Sorcl, datées du 1er juin 1950 et remboursables par séries du 1er juin 1951 au 1er juin 1970 inclusivement.Les soumissions pourront être faites pour des obligations portant intérêt à un taux n'excédant pas 3^2% |'an» payable scini-annucllemcnl les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt offert peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$275,000.00\u201420 ans Année ('a pilai 1er juin 1951.S 9,500.00 1er juin 1952.10,000.00 1er juin 1953.10,500.00 1er juin 1954.11,000.00 1er juin 1955.11,000.00 1er juin 1950.11,500.00 1er juin 1957.12,000.00 1er juin 1958.12,500.00 1er juin 1959.13,000.00 1er juin 1900.13,000.00 1er juin 1901.13,500.00 1er juin 1902.14,000 00 1er juin 1903.14,500.00 1er juin 1904.15,000.00 1er juin 1905.10,000.00 1er juin 1900.10.000.00 1er juin 1907.17,000 00 1er juin 1908.18,000.00 1er juin 1909.18,000.00 1er juin 1970.19.000.00 Public notice is hereby given that sealed lenders, endorsed \"Tenders for Bonds'* will be received by the undersigned, Gaston Laforest, secretary-treasurer, at his office, at 9 Désiré Street, St-Joscph-de-Sorcl, up to 8 o'clock p.m., May 22nd.1050.for the pun base of $275,000 of bonds of the Parish of St.Joseph de Sorel.dated the 1st day of June 1950, and redeemable serially from the 1st day of June 1051 to the 1st day of June 1970 inclusively.Said bids may be made for bonds bearing interest at a rate not exceeding 3j.^% per annum, payable semi-annually on the 1st of June and 1st of December of each year.The rate of interest offered may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of I{cdcniption\u2014$275,0(X).00\u2014?0 years Year Capital June 1st, 1951.S 9,500.00 June 1st, 1952.10,000.00 June 1st, 1953.10,500.00 June 1st, 1954.11,000.00 June 1st, 1955.11,000.00 June 1st, 1950.11,500.00 June 1st, 1957.12,000.00 June 1st.1958.12.500.00 June 1st, 1959.13,000.00 June 1st.1900.13,000.00 June 1st, 1901.13,500.00 June 1st, 1902.14,000.00 June 1st, 1903.14,500.00 June 1st, 1904.15,000.00 June 1st.1905.10,000.00 June .1st.1900.10,000.00 June 1st, 1967.17,000.00 June 1st, 1908.18,000.00 June 1st, 1909.18,000.00 June 1st.1970.19,000.00 Le capital et les intérêts sont payables à toutes Capital and interest will be payable at all tholes succursales, dans la province de Québec, de la branches, in Province of Quebec, of the Bank banque dont le pom est mentionné dans la pro- mentioned in the loan procedure, cédure «l'emprunt.« Ces obligations pourront, sous l'autorité du These bonds may, under authority of Section chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou be redeemed by anticipation, in whole or in part, en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; at par, on any interest payment date; however, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera if such redemption be partial, the bonds to be les échéances les plus éloignées et les numéros les redeemed will be called in reverse order of ma-plus élevés.turity and serial number.Chaque soumission devra être accompagnée Each tender must be accompanied by an d'un chèque accepté égal à 1% du montant de accepted cheque equal to 1% of the amount of l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- the loan and must specify whether the price QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec, April 29th, 1960, Vol.82, No.17 1271 prend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur offered includes or does not include accrued les obligations au moment de leur livraison.interest on the bonds to time of their delivery.Les soumissions seront ouvertes et considérées Tenders will be opened and considered at a à une séance spéciale du conseil qui sera tenue special meeting of the Council, to be held on le 22 mai 1950, à 8 heures p.m., à la salle du Cou- May 22nd.1950, at 8 o'elock p.m.in the hall of vent de St-Joseph, sis sur la rue Léon XIII, à the Convent St.Joseph, Leon XIII Street, at St-Joseph-dc-Sorel.St.Joseph de Sorel.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni The Council docs not bind itself, to accept the la plus haute ni aucune des soumissions.highest nor any of the tenders.St-Joscph-de-Sorel, comté de Richelieu, ce dix- St.Joseph de Sorcl, county of Richelieu, this huitième jour d'avril 1950.eighteenth day of April Î950.27359-0 l,c Secrétaire-trésorier, GASTON LAFOREST, 9, rue Désiré, St- Joseph -dc-Sorel, (Richelieu) P.Q.27359-0 GASTON LAFOREST, Sccrctary-Treasu rer, 9, Désiré Street, St.Joseph de Sorek (Richelieu) P.Q.Ventes \u2014 Loi de faillite Sales \u2014 Bankruptcy Act Province de Québec, district de Jolicttc, Cour Supérieure (En matière de faillite) no 386, In rb: JOSEPH alias JOSAITIAT BEAU-SOLEIL, camionneur, de Saint-Gabriel de Brandon, district de Joliette.('édani-Autorisé.Avis est par les présentes donné que MERCREDI, le DIX-SEPTIEME jour de MAI 1950.à DIX heures «le l'avant-midi, à la porte de l'église paroissiale de Saint-Gabriel de Brandon, «listrict de Joliette, seront vendus, par encan public, au plus haut et dernier enchérisseur, les immeubles suivants cédés par le cédant-autorisé, en cette cause, savoir: \"Un immeuble situé au village «le Saint-Gabriel de Brandon, ayant front sur la rue Michaud.composé des numéros deux-cent trente et un-vingt-sept, deux cent trente et un-vingt-huit, deux cent trente et un-soixante et «lix, «leux cent trente et un-soixante et douze et deux cent trente et un-soixante et tieize-A (Nos 231-27.28, 70, 72 et 73-A) au cadastre du village «le Saint-Gabriel «le Brandon, borné en front par la rue Michaud.à la profondeur par la rue Alfred, au c«*>té nord-ouest par la rue Beauvilliers et au c«*>té sud-est par Alban Lafortunc (no-231 -2(>) et Louis Rainville (No 231-73-B) avec une bâtisse servant de magasin et de logement et autres bâtisses y édifiées.\"A distraire au coin sud du numéro «leux cent trente
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.