Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 mai 1950, samedi 20 (no 20)
[" Tome 82, N# 20 1419 Vol.82, No.20 (Drapeau de la province de Québec, adopté par arrêté en conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.)! (Flag of tbe Province of Quebec, adopted by order in Council Number 72, bearing date January 21st, 1948.) zette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pu bu shed by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 20 mai 1950 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, May 20th, 1950 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 1420 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20, mai 1950, Tome 82, N° 20 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publics dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises (l'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.0° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.ITarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement : S7 par année.N.1$.\u2014 I-es chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.I.es avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the Interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first inseition; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMF1T PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439 \u20141-52 Lettres patentes A La Porte St-Jean Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1950.constituant en corporation: Rcné-B.Robert, entrepreneur, de Beau-port, district, judiciaire de Québec, Noël Couture, agent, de Montréal, et Georges Bérubé, vendeur, de Dorval, tous deux du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de restaurateur, pâtissier et hôtelier, sous le nom de \"A la Porte St-Jean Ltée\", avec un capital de §99,000 divisé en 500 actions privilégiées de 8100 chacune et en 490 actions ordinaires de S100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de 815,000.Le siège social de la compagnie sera à 99, rue Saint-Jean, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le onze avril 1950.L'Assistant-procureur général.27505-o L.DÉSILETS.Letters Patent A La Porte Si-Jean Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1950, incorporating: René \\i.Robert, contractor, of Beauport,judicial district of Quebec, Noel Couture, agent, of Montreal, and Georges Bérubé, salesman, of Dorval.both of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and trade of restaurant-keeper, pastry-cook, and hotel-keeper, under the name of \"A La Porte St-Jean Ltée\".with a capital stock of 899,000, divided into 500 preferred shares of 8100 each, and 490 common shares of 8100 each, and the amount with which the company will begin its operations is 815,000.The head office of the company will be at 99 Saint-John Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh (lav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27505.Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1421 Arlhur-h.Caron Limitée Avis est- donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a .'\u2022u'- accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation: Artbur-H.Caron, commerçant, Dame Florence Catellier Caron, ménagère, épouse contractuelleinéht séparée de biens de Artbur-H.Caron et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Jean Caron, commerçant, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: \u2022 Faire le commerce de vêtements, sous le nom de \"Arthur-H.Caron Limitée\", avec un capital de $30,000 divisé en 3,000 actions de $10 chacune.Ix> siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.Building Management Corporation Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 27li.S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-huit mars 1950.constituant en corporation: Claude Sartoris Richardson, avocat et conseil en loi du Roi, Ernest William Mockridge, \"('\u2022rant, William Patrick Creagh et Alexander Cordon Yeoman, commis en loi, Clifford George Meek et Charles Eric Humphrey, teneurs de livres et John Lawrence McCrory, secrétaire, tons des cités et district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Faire des affaires connue propriétaires et gérants d'immeubles, sous le nom de \"Building Management Corporation\".Le capital autorisé de la compagnie sera composé de 25,000 actions sans valeur nominale ou au pair; et le montant avec lequel la compagnie exercera son commerce ne sera pas moins (pie s 125.000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit, mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DESILETS.Cinq Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept mars 1950, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, William Patrick Creagh, commis en loi et Clifford George Meek, teneur de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire les affaires d'une compagnie d'immeubles et de biens immobiliers, sous le nom de \"Cinq Corporation Limited\", avec un capital de $5.000 divisé en 50 actions d'une valeur au pair de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie fera ses-affaires sera de §500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Arthur-II.Caron Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating: Arthur H.Caron, merchant, Dame Florence Catellier Caron, housewife, wife separate as to property by marriage contract of Arthur H.Caron and duly authorized by him for the purposes hereof, and Jean Caron, merchant, all of the city ami judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in clothing, under the name of \"Arthur IL Caron Limitée\", with a capital stock of $30,000 divided into 3,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Building Management Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity, with section 2, chapter 276,R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eighth day of March, 1950, incorporating: Claude Sartoris Richardson, advocate and King's Counsel Ernest William Mockridge, manager, William Patrick Creagh and Alexander Gordon Yeoman, law clerks, Clifford George Meek and Charles Eric Humphrey, bookkeepers, and John Lawrence McCrory, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate proprietors and managers, under the name of \"Building Management Corporation\".The authorized share capital of the company shall consist of 25,000 shares without nominal or par value; and the amount with which the company will carry on its business shall be not less than 8125,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General.Cinq Corporation Limited Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1950, incorporating: Ernest William Mockridge,' manager, William Patrick Creagh, law clerk, and Clifford George Meek, bookkeeper, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and immoveable company, under the name of \"Cinq Corporation Limited\", with a capital stock of 85,000 divided into 50 shares of the par value of 8100.each, and the amount with which the company will carry on its business is 8500.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General. 1422 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 20 mai 1950, Tome 82, N° 20 Club Kinsmen de St-Jérôme Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Emile Francœur, gérant.Jean-E.Mélanger, comptable, et Marc Boucher, avocat, tous de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Recueillir des fonds pour fins de charité et de bienfaisance, sous le nom de \"Club Kinsmen de St-Jérôme Inc.\" Les pouvoirs accordés ne peuvent être interprétés comme permettant les jeux de hasard, les jeux mixtes de hasard et d'habileté, et les paris illégaux.De plus, la corporation ne sollicitera pas et n'opérera pas de licence ou permis accordés par la Commission des Liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers (pie la corporation peut posséder est de $15,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un mars 1950.L'Assistant-procureur général.27000-0 L.DÉSILETS.Continental Glass Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation: Albert Marcus, Isidore Pra/off et Abraham Feincr, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie, le commerce et.fabriquer tous verres et produits en verre, sous le nom de \"Continental Glass Company\", avec un capital de 840,000 divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Ta; siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Cote des Neiges Building Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1950, constituant en corporation: David Goodman, Philip Fischel Vine-berg, avocats et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme propriétaires et gérants d'immeubles, sous le nom de \"Côte des Neiges Building Corporation\", avec un capital de S7.5,000 divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et en 6,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1950.L'Assistant-proeureur général.27505 L.DÉSILETS.Club Kinsmen de St-Jérôme Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have l>cen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Emile Francœur, manager, Jean E.Bélanger, accountant, and Marc 1 Joncher, advocate, all of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To collect funds in aid of charitable and welfare works, under the name of \"Club Kinsmen de St-Jérôme Inc.\" The powers conferred shall not be interpreted as permitting games of chance, games of chance ans skill combined, and illegal betting.Moreover, the corporation shall not apply for nor operate a license or permit granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to.which the immovable property which the corporation may hold is to lie limited, is 815,000.The head office of the corporation will be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Continental Glass Company .Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating: Albert Marcus, Isidore Prazoff and Abraham Feincr, advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on trade, business and manufacture of all glass and glass products, under the name of \"Continental Glass Company\", with a capital stock of 840,000 divided into 200 common shares of 100 each, and 200 preferred shares of SI00 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General.Cote des Neiges Building Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1950, incorporating: David Goodman, Philip Fischel Vinebcrg, advocates, and Yvonne Bélanger, secretary, spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate proprietors and managers, under the name of \"Côte des Neiges Building Corporation\", with a capital stock of 875,000 divided into 1,500 common shares of the par value of 810 each, and 6,000 preferred shares of the par value of S10 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950', Vol.82, No.20 1423 C.W.Smiley & Son Ltd.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize mars 1950, constituant en corporation: Roy Fraser Elliott, avocat, Amy Jean Fitzgerald et Lillian Viola Armstrong, sténographes, lilies majeures, tous des cité et district judiciaire do Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de combustible, lubrifiants, bois de charpente et bois de construction en général, sous le nom de \"C.W.Smiley & Son Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 2.000 actions d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 698 avenue Victoria, St-Lambcrt, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.C.W.Smiley & Son Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of March.1950, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, Amy Jean Fitzgerald and Lillian Viola Armstrong, stenographers, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealer generally in fuel, lubricants, timber and lumber, under the name of \"('.\\V.Smiley & .Son Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 2,000 shares of the par value of $10 each.The head office of the Company will be at 098 Victoria Avenue, St.Lambert, in the Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General.Deniers Limitée Deniers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mars 1950, constituant en corporation : William Morin, C.R., avocat, André Verge, avocat, et Fleurette Dussault, secrétaire, tous des cité et district, judiciaire de Québec pour les objets suivants: faire le commerce d'épicerie, sous le nom de \"Deniers Limitée\"\u2014\"Deniers Limited', avec un capital de 820.000 divisé en 200 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à West-inount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-scpl mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-O L.DÉSILETS.Deniers Limitée Deniers Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of March, 1950, incorporating: William Morin.K.C., advocate, André Verge, advocate, and Fleurette Dussault, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on a grocery business, under the name of \"Deniers Limitée\"\u2014\"Deniers Limited\", with a capital stock of 820.000.divided into 200 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Wcstmount, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of March, .1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Ednor Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a élé accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date ilu quinze mars 1950, constituant en corporation: llyinan Eric Feigclson, Lionel Albert Sperber, Nathaniel JiConard Rappaport, avocats, et James Topping, surintendant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et manufacturiers de produits textiles, sous le nom de \"Ednor Corporation\", avec un capital de $250,000 divisé en 1,000 actions privilégiées de première catégorie \"A\" d'une valeur au pair de M00 chacune, en 1,400 actions privilégiées de deuxième catégorie \"B\" d'une valeur au pair de \u2022S 100 chacune et en 10,000 actions ordinaires \u2022l'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montreal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Ednor Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of March, 1950, incorporating: Hyman Eric Fcigelson.Lionel Albert Spcrber, Nathaniel Leonard Rappaport, advocates, and James Topping, superintendent, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as textile dealers and manufacturers, under the name of \"Ednor Corporation\", with a capital stock of 8250,000 divided into 1,000 first preferred class \"A\" shares of a par value of 8100 each.1,400 second preferred class \"B\" shares of a par value of 8100 each, and 10,000 common shares of a par value of 81.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the attorney general this fifteenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General. 1424 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai 1950, Tome 82, N° 20 Eug.Dubois Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1950, constituant en corporation: Jeanne Martincau Dubois, marchande, épouse séparée de biens de Wilfrid Dubois, et Wilfrid Dubois, agent à commission, Maurice Dubois, gérant, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de chaussures, sous le nom de \"Eug.Dubois Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 709, rue St-Yallier, Québec, distict judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept mars 1950.L'Assistant-procureur général.27505-o L.DÉSILETS.Fashion Laces Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation: Mclvin Salmon, avocat, iilanka Gyulai, veuve, teneuse de livres, Mariette St-Arnaud et Betty Pomerant/., secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le négoce ou le commerce de dentelles, broderie, soieries, lainages, cotonnades et autres tissus de toute nature et description, sous le nom de \"Fashion Laces Ltd.\", avec un capital de 860,000 divisé en 400 actions privilégiées de 8100 chacune et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Fit Right Dress Mfg.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation: Jacob Solomon Sandler, manufacturier, Dame Reba Gross, ménagère, épouse séparée de biens de Jacob Solomon Sandler, tous deux de la cité de Montréal et Abraham Harold Crestohl, gérant, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général de vêtements, sous le nom de \"Fit Right Dress Mfg.Ltd.\", avec un capital de 875,000 divisé en 750 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Eug.Dubois Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1950, incorporating: Jeanne Martincau Dubois, merchant, wife separate as to property of Wilfrid Dubois, and Wilfrid Dubois, commission agent, Maurice Dubois, manager, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in footwear, under the name of \"Eug.Dubois Inc.\", with a capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 769 St-Yallier Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Fashion Laces Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating: Mclvin Salmon, advocate, Blanka Gyulai, widow, bookkeeper, Mariette St-Arnaud and Betty Pomerant/, secretaries, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with laces, embroidery, silks, woollens, cottons and other materials of every nature and description, under the name of \"Fashion Laces Ltd.\", with a capital stock of 860,000 divided into 400 preferred shares of 8100 each, and 200 common shares having a par value of 8100 each.The head office of the Company will be at Montréal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentv-sccond day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General.Fit Right Dress Mfg.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of t he-Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating: Jacob Solomon Sandler, manufacturer, .Dame Reba Gross, housewife, wife separate as to property of Jacob Solomon Sandler, both of the City of Montréal, and Abraham Harold Crestohl, manager, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in wearing apparel, tinder the name of \"Fit Right Dress Mfg.Ltd.\", with a capital stock of 875,000 divided into 750 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second dav of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1425 Garage St-Jacques Incorporé St.James Garage Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic dé la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres'patentes, en date du vingt-sept mars 1950, constituant en corporation: Jacques Raymond, comptable agréé, Claude Lamy, comptable, tous deux de la cité de Montréal, et Guy Chabot, comptable agréé, d'Outre-mont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de garagiste, sous le nom de \"'Garage St-Jacques (Incorporé\"\u2014\"St.James Garage Incorporated', avec un capital de $1(5,000 divisé en 50 actions ordinaires de $20 chacune et en 300 actions privilégiées de $50 chacune.I.e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.Garage St-Jacques Incorporé St.James Garage Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1950, incorporating: Jacques Raymond, chartered accountant.Claude Lamy, accountant, both of the city of Montreal, and Guy Chabot, chartered accountant, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of garage keeper, under the name of \"Garage St-Jacques Incorporé\"\u2014\"St.James Garage Incorporated\", with a capital stock of SI(5.000 divided into 50 common shares of S20 each and 300 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney 'General, this twenty-seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Geo.Lambert Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mars 1950, constituant en corporation: Claude Lamy, Jacques Raymond, comptables, de la cité de Montréal, et Guy Chabot, comptable, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal,, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de matériaux dc-construction et agir comme entrepreneur généraux, sous le nom de \"Geo.Lambert Incorporée\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 2,500 actions sans valeur au pair ou nominale et en 3.000 actions privilégiées de $25 chacune et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de S'25,000.Ix* siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, distiict judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.Geo.Lambert Incorporée Notice is hereby given that under l'art.I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «.f Quebec, bearing date the seventeenth day of March, 1950, incorporating: Claude Lamy, Jacques Raymond, accountants, of the city of Montreal, and Guy Chabot, accountant, of the city of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes.To manufacture and deal in building materials, and act as general contractor, under the name of \"Geo.Lambert Incorporée\".The capital stock of the company will be divided into 2.500 shares without nominal or par value, and 3,000 preferred shares of S25 each, and the amount with which the company will begin its operations is $25,000.The head office of the company will be at Trois-Rivières.judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Granby-U-Drive Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1950, constituant en corporation: Paul-Emile Brouillard, garagiste, Jean-Paul Ber-uier, comptable, tous deux de Granby, et Jean-Marc I'otvin, garagiste, de West-Shcfford, tous du district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Exercer le commerce de location d'automobiles, sous le nom de \"Granby-U-Drive Ltd.\", avec un capital «le $40.000 divisé en 400 actions de $100 chacune.lie siège social «le la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau «lu Procureur général le neuf février 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.Granby-U-Drive Ltd.Notice is hereby given that under part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1950, incorporating: Paul-Émile Brouillard, garage-keeper, Jean Paul Bernier, accountant, both of Granby, and Jean Marc Potvin, garage-keeper, of West Shefford, judicial district of Bedford, for the following purposes: To carry on the business of the leasing of automobiles, under the name of \"Granby-U-Drive Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of Si00 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General. 142G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai 1950, Tome 82, N° 20 Holel Terminal Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Licutenant-gouveineur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1950, constituant en corporation: Bernard Lacroix, ex-hôtelier, de La-chine, Philippe Houdc, gérant d'hôtel, et Gédéas Clermont, bourgeois, ces deux derniers de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtelier, sous le nom de \"Hôtel Terminal Ltée\", avec un capital de S145.000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 1,250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.Hotel Terminal Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1950, incorporating: Bernard Lacroix, ex hotel-keeper, of Lachine.Philippe Houdc, hotel manager, and Gédéas Clermont, bourgeois, the two latter of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hotcl-kcei>er, under the name of \"Hôtel Terminal Ltée\", with a capital stock of $145,000, divided into 200 common shares of $100 each, and 1,250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.La Compagnie Forgues, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mars 1950, constituant en corporation: Camille Forgues, distributeur, Emile Forgues, conducteur, de Bienville, et Paul Chartrain, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce des produits et sous-produits du lait et d'appareils frigorifiques, sous le nom de \"La Compagnie Forgues, Ltée\", avec un capital de $28,000 divisé en 280 actions ordinaires de Si00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6, rue Begin, Bienville, Lan/.on, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.La Jeunesse Indépendante Catholique Féminine du Canada Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mars 1950, constituant en corporation sans capital actions: Marie-Alice Cadicux, institutrice, de Montréal-Nord, Juliette Boivin, secrétaire, Claire Vaillan-court, étudiante, toutes deux de la cité de Montréal, Denise Gauthier, secrétaire, d'Outremont, toutes du district judiciaire de Montréal, et Renée Blanchard, de Ste-Thérèse, district judiciaire de Terrebonne,.pour les objets suivants: Travailler à la formation sociale et religieuse des jeunes filles du milieu bourgeois et des classes moyennes, sous le nom de \"La Jeunesse Indépendante Catholique Féminine du Canada\".La valeur maximum des immeubles que la corporation pourra posséder est fixée à $100,000.Le siège social de la corporation sera à Outremont, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.La Compagnie Forgues, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of March, 1950, incorporating: Camille Forgues, distributor, Emile Forgues, conductor, of Bienville, and Paul Chartrain, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in the products and by products of milk and in refrigerating equipment, under the name of \"La Compagnie Forgues, Ltée\", with a capital stock of $28,000 divided into 280 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 6 Begin street, Bienville, Lauzon, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.La Jeunesse Indépendante Catholique Feminine du Canada Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of March, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Marie Alice Cadieux, teacher, of Montreal North, Juliette Boivin, secretary, Claire Vaillancourt, student, both of the city of Montreal, Denise Gauthier, secretary, of Outremont, all cf the judicial district of Montreal, and Renée Blanchard, of Ste-Thérèse, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To work for the social and religious training of young girls of the middle class and the like, under the name of \"La Jeunesse Indépendante Catholique Féminine du Canada\".The maximum value of the immovable property which the corporation may hold is fixed at $100,000.The head office of the corporation will be at Outremont, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1427 Les Entreprises Meteor, Ltée Meteor Enterprises, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a «'\u2022lé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1950, constituant en corporation: Wilfrid Robitaille, technicien, Edmond (ïuevremont, mécanicien, et Roger Dragoy, chef de personnel, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Les Entreprises Metéor, Ltée\" \u2014 \"Meteor Enterprises, Ltd.\", avec un capital de 8100,000 divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune et en 1,900 actions privilégiées de S50 chacune.Ix> siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505-o L.DÉSILETS.Modern Fur Dyers & Blenders Limitée Modem Fur Dyers & Blenders Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mars 1950, constituant en corporation: Armand Lozeau, industriel, Denis Lozeau, teinturier, et Jack Lee, teinturier chimiste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de fourrures, sous le nom «le \"Modem Fur Dyers & Blenders Limitée\"\u2014 \"Modem Fur Dyers & Blenders Limited\", avec un capital de S40,000 divisé en 250 actions ordinaires de S100 chacune et en 150 actions privilégiées d'une valeur de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4214, rue des Érables, Montréal, district judiciaire de Montréal.« Daté du bureau du Procureur général le dix-huit mars 1950.L'Assistant-procureur général.27505-o L.DÉSILETS.Les Entreprises Metéor, Ltée Meteor Enterprises, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first (lay of March, 1950, incorporating: Wilfrid Robitaille, technician, Edmond Gucvremont, mechanic, and Roger Dragoy, Personnel manager, all of the city and judicial district of .Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Les Entreprises Metéor, Ltée\" \u2014 \"Meteor Enterprises, Ltd.\", with a capital stock of S 100.000, divided into 5,000 common shares of SI each, and 1,900 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Modern Fur Dyers & Blenders Limitée Modern Fur Dyers & Blenders Limited Notice is hereby given that under Part' I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1950, incorporating: Armand Lozeau, industrialist.Denis Lozeau, dyer, and Jack Lcc, dyer, chemist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the fur business, under the name of \"Modern Fur Dyers &\u2022 Blenders Limitée\"\u2014 \"Modern Fur Dyers and Blenders Limited\", with a capital stock of 840.000, divided into 250 common shares of 8100 each, and 150 preferred shares of the value of 8100 each.The head office of the company will be at 4214 des Érables Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.National Clock Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation : Charles Brownstein, avocat, Harry A.Luttcrman, marchand, et Mary Steiman, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme orfèvres, joaiU liers, bijoutiers et graveurs, sous le- nom de \"National Clock Co.Ltd.\", avec* un capital de $50,000 divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de \u2022S 100 chacune.I* siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.National Clock Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating-Cbarlcs Brownstein, advocate, Harry A.Lutter-man, merchant, and Mary Steiman, secretary, spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following puiposes: To carry on the business of goldsmiths, silversmiths, jewellers and engravers, under the name of \"National Clock Co.Ltd.\", with a capital stock of S50.000, divided into 250 common shares at the par value of $100 each, and 250 preferred shares at the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505-o Deputy Attorney General. 1428 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai I960, Tome 82, N° 20 Racine Mfg.Co.Ltd.Avis est donné «m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéliec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mars 1950.constituant en corporation: Maurice Racine.Julien Racine, manufacturiers, et (ailles Racine, comptable, de la cité de Granby, district judiciaire de Bedford, poulies objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'appareils de réfrigération, sous le nom de \"Racine Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital de 8300,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 8100 chacune et en 1,000 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27Ô05-o L.DÉSILETS.Racine Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have beeh issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1950, incorporating: Maurice Racine, Julien Racine, manufacturers, ami (lilies Racine, accountant, of the city of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To manufacture and deal in refrigerating equipment, under the name of \"Racine Mfg.Co.Ltd.\", with a capital stock of 8300,000 divided into 2,000 common shares of 8100 each ami 1,000 preferred shares of SI00 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27505 Deputy Attorney General.Skyway Service Stations Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1950, constituant en corporation: Samuel Greenhlatt, Samuel E.Schwis-berg, Charles Wolf.son, avocats, Sonya Schneyer et Alva Phyllis Boyd, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme propriétaires de garage, sous le nom de \"Skyway Service Stations Inc.\", avec un capital de SS0.000 divisé en 800 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1425 rue de la Montagne, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Skyway Service Stations Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1950, incorporating; Samuel Greenblatt.Samuel E.Schwisberg, Charles Wolfson.advocates, Sonya Schneyer and Alva Phyllis Boyd, secretaries, spinsters, all of tIn-City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage operators, under the name of \"Skyway Service Stations Inc.\", with a capital stock of 880,000 divided into 800 shares of 8100 each.The head office of the Company will be at 1425 Mountain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of March.1950.L.DÉSILETS.27505-o Deputy Attorney General.St.Catherine Public Meat Market Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation: Samuel E.Sclnvisl>erg, conseil en loi du Roi, Cyril E.Schwisberg, avocat, tous deux de la cité d'Outremont, et Sonya Schneyer, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme bouchers, fournisseurs de provisions, propriétaires de salaisons et épiciers, sous le nom de \"St.Catherine Public Meat Market Ltd.\", avec un capital de 850,000 divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27505 L.DÉSILETS.Tewkesbury Lumber Corporation St.Catherine Public Meat Market Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tla-Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating: Samuel E.Schwisberg, King's Counsel.Cyril E.Schwisberg, advocate, both of the City of Outremont, and Sonya Schneyer, secretary, fille majeure of the city of Montreal all » To whom it may concern: The council of the municipality of the village of Mont-Laurier, county of Labelle, Province of Quebec, hereby gives notice of its intention to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1433 tention d'ériger la municipalité du village de Mont-Laurier en Municipalité de ville.0) Le nom de la municipalité projetée sera \"La Municipalité de la ville de Mont-Laurier\"./;) Le territoire de ladite municipalité de la ville de Mont-Laurier comprendra: \"La partie ouest de chacun des lots numéros 20 à 26 incl.du rang 1 du canton de Campbell ainsi que les deux îles de la rivière du Lièvre, situées en face des lots numéros 23 et 22 du dit rang et elle est bornée comme suit, savoir: Au nord, par le lot numéro 27 du dit rang; au sud par le lot no.19 du même rang; à l'est, par une ligne droite menée transversalement aux dits lots numéros 20 à 26 à partir du point où la ligne séparation des lots numéros 19 et 20 du dit rang rencontre la rive gauche du ruisseau Villemaire de manière à joindre les deux bornes en bois de chêne, plantées l'une sur la ligne séparation Lots 19 et 20 et l'autre sur celle des lots 26 et 27, pour indiquer la limite est de la dite municipalité; enfin, vers l'ouest, par la ligne de profondeur des eaux dans la dite rivière du Lièvre, sera détachée dc la municipalité du Canton de Campbell, et formera une municipalité séparée sous le nom de la \"Municipalité du Village dc Mont-Laurier.\" 1) les lots nos.52 et 53 du rang II du canton Robertson; 2) les lots nos.51, 52 et 53 du rang III, même canton.c) Le recensement de la population du village dc Mont-Laurier s'établit à 4,485 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq) Ames, tel que constaté par un recensement ordonné par le conseil, le 17 février 1950; d) L'érection de la municipalité de la ville de Mont-Laurier se fera sous l'empire de la Loi des Cités et Villes, Ch.233 S.R.P.Q.1941 et ses amendements.Et le présent avis est publié à toutes fins que de droit.Mont-Laurier, ce 20 avril 1950.Le Secrétaire-trésorier de la municipalité du village de Mont-Laurier, 27348-17-4-0 LÉO PAQUETTE.Corporation municipale de Chandler GaSPÉ TIRAGE D'OBLIGATIONS Les obligations suivantes, émises sous l'autorité du règlement N° 03, ont été tirées au sort: Dénomination de $100.00: Nos 7, 95, 166, 170.171 et 178; Dénomination de 8500.00: Nos 5, 22, 136, 153, 107 et 181.Lesdites obligations sont remboursables le 1er juillet 1950, date à laquelle elles cessent de porter intérêt.Le Secrétaire-trésorier, 27509-o WILBROD LUCAS.erect the municipality of the village of Mont-Laurier into a Town municipality.a) The name of the proposed municipality to be \"The Municipality of the Town of Mont-Lau-rier\".b) The territory of the said municipality of the town of Mont-Laurier will consist of : \"The west part of each of lots numbers 20 to 26 incl., of range 1 of the Township of Campbell and also the two islands of the \"du Lièvre\" river, situate in front of lots numbers 23 and 22 of said range and it is bounded as follows, to^wit: on the north, by lot number 27 of said range; on the south by lot No.19 of the same range; on the east, by a straight line drawn transversally to said lots numbers 20 to 26 starting from the point where the division line of lots numbers 19 and 20 of said range meets the left bank of the Villemaire stream so as to join the two oak wood boundaries planted, one on the division line of lots 19 and 20 and the other on that of lots 26 and 27, to indicate the east limit of the said municipality; finally, towards the west, by the depth line of the waters of the said river \"du Lièvre\", to be detached from the municipality of the Township of Campbell, and to form a separate municipality under the name of the \"Municipality of the Village of Mont-Laurier.\" 1) Lots Nos.52 and 53 of range II of the township Robertson; 2).Lots Nos.51, 52 and 53 of range III, same township.c) The census of the population of the village of Mont-Laurier is established at 4,485 (four thousand four hundred and eighty-five) souls, as ascertained by a census ordered by the Council, on the 17th of February, 1950; d) The erection of the municipality of the Town of Mont-Laurier shall be made under the authority of the Cities and Towns Act, chapter 233, R.S.Q., 1941 and its amendments.And the present notice is published to all intents and purposes.Mont-Laurier, April 20, 1950.LÉO PAQUETTE, Secretary Treasurer of the Municipality 27348-17-4 of the Village of Mont-Laurier.Municipal Corporation of Chandler Gaspf.DRAWING OF BONDS The following bonds, issued under authority of By-law No.03, have been drawn by lots: Denominations of 8100: Nos.7, 95,\" 166, 170, 171 and 178; Denominations of 8500: Nos.5, 22, 136, 153, 167 and 181.The said bonds will be redeemable on the 1st of July, 1950, the date upon which they shall cease to bear interest.WILBROD LUCAS, 27509 Secretary-Treasurer.Cadillac Restaurant Limited Règlement N° 19 Cadillac Restaurant Limited By-Law No.19 Un règlement pour augmenter le nombre des A By-Law to Increase the number of Directors directeurs de la compagnie of the Company Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, Be it enacted and it is hereby enacted as a décrété comme un règlement dc la compagnie By-Law of \"Cadillac Restaurant Limited\" that \"Cadillac Restaurant Limited\" que le nombre the number of the Board of Directors of the 1434 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, %Q mai 1050, Tome 82, JV° 20 des membres du bureau de direction de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté dc trois à quatre, desquels trois formeront quorum à toute assemblée et que le règlement B numéro 2, article 1 soit et il est, par les présentes, modifié en conséquence.Décrété le 14 avril 1950.(Sceau) Le Président, C.SCHOOLARINOS.lie Secrétaire, 27510 J.-ALP: LEMAY.Diana Restaurant, Inc.Règlement A'0 XXIII Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs dc la compagnie.Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie \"Diana Restaurant, Inc.\" que le nombre des membres du bureau de direction de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté dc trois à quatre, desquels trois formeront quorum à toute assemblée, et (pic le règlement N° I, article 1 et le règlement N° 12, article 5 soient et ils sont, par les présentes, modifiés en conséquence.Décrété le 14 avril 1950.Le President.(Sceau) C.SCHOOLARINOS.Le Secrétaire, 27511 J.-ALP.LEMAY.Avis est donné que, sur recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a approuvé, en date du 8 mai 1950, certains amendements aux règlements de \"Saguenay Country Club\", tels qu'adoptés à une assemblée tenue le 21 mars 1950, conformément aux dispositions de.l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 8 mai 1950.Le Sous-secrétaire dc la Province, 27512 JEAN BRUCHÉSI.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le 10 mai 1950, le changement de nom de \"Le Syndicat Catholique des Maîtres-Barbiers et Coiffeurs de la Juridiction de St-Hyacintbe\" en celui dc \"Syndicat National Catholique des Barbiers-Coiffeurs et Coiffeuses pour Dames dc St-Hyacinthc et sa Juridiction, Inc.\", et ce conformément aux dispositions fies articles 7 et 8 dc la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 11 mai 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27513-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 27 mars 1950, les règlements I à VIII inclusivement et X à XV inclusivement de \"L'Association Forestière Québécoise \", tels qu'adoptés à la dernière assemblée annuelle tenue le 1er février 1950, Company be and same is hereby increased from three to four, of which three shall form a quorum at any meeting, and that By-Law B Number 2, Section I, be and same is hereby amended accordingly.Enacted this 14th day of April 1950.(Seal) C.SCHOOLARINOS, President.J.-ALP.LEMAY, 27510-o Secretary.Diana Restaurant, Inc.By-Law No.XXIII A By-Law to increase the number of Directors of the Company.Be it enacted and it is hereby enacted as a By-Law of \"Diana Restaurant Inc.\", that the number of the Board of Directors of the Company be and same is hereby increased from three to four, of which three shall form a quorum at any meeting, and that by-law No.I, Section 1, and By-Law No.12, Section 5, be and same are hereby amended accordingly.Enacted this 14th day of April 1950.C.SCHOOLARINOS, (Seal) President.J.ALP.LEMAY, 2751 l-o Secretary.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved on May 8th, 1950, certain amendments to the by-laws of \"Saguenay Country Club\", as adopted at a meeting held on March 21st, 1950, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276).Given at the office the Provincial Secretary this 8th of May,.1950.JEAN BRUCHÉSI, 27512-0 Under Secretary of the Province.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized, on May 10th, 1950, the change of name of \"Le Syndicat Catholique des Maître-Barbiers et Coiffeurs de la Juridiction de St-Hyacinthc\" into that of Syndicat National Catholique des Barbiers-Coiffeurs et Coiffeuses pour Dames de St-Hyacinthc et sa Juridiction, Inc.\", and such, pursuant to the provisions of sections 7 and 8 and of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, this eleventh day of May, 1950.; JEAN BRUCHÉSI, 27513 Under Secretary of the Province.Notice is given that upon recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary, on March 27th, 1950, approved By-law I to VIII inclusively and X to XV inclusively of \"L'Association Forestière Québécoise\" as adopted at the last annual meeting held the 1st February, 1950, and such QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1435 et ce conformément aux disposition» de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 270), telles que modifiées par 10 Geo.VI, chapitre 20, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 28 mars 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27525-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association des Policiers de Sherbrooke\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 13 mai 1950.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sherbrooke, comté de Sherbrooke.Le Sous-secrétaire de la Province, 27526-0 JEAN BRUCHÉSI.in conformity with the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276) as amended by 10 George VI, chapter 20, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, March 28, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27525 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association des Policiers de Sherbrooke\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 13, 1950.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sherbrooke, county of Sherbrooke.JEAN BRUCHÉSI, 27526 Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 8 mai 1950, les règlements de \"Les Chemins d'Hiver de St-Bruno\", comprenant les articles 1 à 19 inclusivement, et ce conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 10 mai 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27535-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice is given that upon recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary, on May 8, 1950, approved the by-laws of \"Les Chemins d'Hiver de St-Bruno\", including articles 1 to 19 inclusively, and such pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276).Dated at the office of the Provincial Secretary, May 10, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27535 Under Secretary of the Province.AVIS NOTICE (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicates' Act) La formation d'une société, sous le nom de \"Le The formation of an association under the Syndicat de l'U.C.C.de St-Octave-de-Dosquet\", name of \"Le Syndicat dc l'U.C.C.de St-Octave-pour l'étude, la défense et le développement des de-Dosquet\" for the study, defence and promo-intérêts économiques, sociaux et moraux de ses tion of the economic, social and moral interests membres, a été autorisée par le Secrétaire de la of its members has beeen authorized by the Pro-Province le 10 mai 1950.vincial Secretary on May 10, 1950.Ix; siège social du syndicat professionnel pré- The principal place of business of the said cité est situé à Saint-Octave-de-Dosquet, comté professional syndicate is at Saint-Octave-de- de Lotbiniere.Dosquet, county of Lotbinière.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 27536-0 JEAN BRUCHÉSI.27536 Under Secretary of the Province.Paroisse de St-Camille-de-Lellis Bellechasse Tirage d'obligations Les obligations suivantes, émises sous l'autorité du règlement no 99, ont été tirées au sort: Parish of St-Camille-de-Lellis Bellechasse Drawing of Bonds The following bonds, issued under authority of By-law No.99, have been drawn by lots: Dénomination de $500.00.Nos 18, 37, 44.Denomination of 8500.00.Nos.18, 37, 44.Dénomination de $100.00.Nos 7, 12, 47, 65, Denomination of $100.00.Nos.7, 12, 47, 65, 72, 75, 78, 79 et 90.72, 75, 78, 79 and 90.Dénomination de $70.00.Nos 5, 6 et 8.Denomination of $70.00.Nos.5, 6 and 8.Au total de $2,610.00.Total amount : $2,610.Les dites obligations sont remboursables le The said bonds shall be redeemable on July, 1er juillet 1950, date à laquelle elles cesseront de 1950, from which date they shall cease to bear porter intérêt.interest.Le Secrétaire-trésorier, E.A.MORIN, 27537-0 E.-A.MORIN.27537 Secretary-Treasurer. 1430 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai 19ÔO, Tome 82, N° 20 ( hartes \u2014 Abandon Je C.Ciia.mpoux Inc.En vertu des dispositions de la Loi des Compagnies de la province de Québec, \"C.Champoux Inc.\" donne avis, par les présentes, qu'elle s'adressera à l'Honorable Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales de l'Industrie et du Commerce de la province de Québec pour obtenir l'abandon de sa charte et son annulation à partir d'une date qui sera fixée par eux.Québec.12 mai 1950.\\jC Secrétaire, 27514-o A.-ÉMILE BEAUVAIS.SeLECTA GlRDLE INC.AVIS En vertu des dispositions de la loi des compagnies de Québec, telle qu'amendée.\"Selecta Girdle Inc.\" donne avis par les présentes, qu'elle fera application à l'Honorable Procureur Général de la Province de Québec pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en ordonne son annulation, et fixe une date à compter de laquelle elle sera dissoute.Québec, P.Q., le 11 mai 1950.Le Secrétaire, 27515-o PIERRE AMYOT.Avis est par les présentes donné que \"Inter-American Fisheries Limited\", constituée en corporation par Lettres Patentes en date du 1er mai 1917, s'adressera au Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce,conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies dc Québec, pour demander l'abandon de sa charte et son annulation A compter de la date qu'il plaira audit Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce, de fixer.Daté à Montréal, ce 9ièmc jour dc mai, 1950.Le Secrétaire de Inter-American Fisheries Limited, 2753S-o MARCEL PICHÊ.Charters - Surrender of C.Champoux Inc.Under the provision of the Quebec Companies' Act, \"C.Champoux Inc.\" hereby gives notice that this company will apply to the Attorney General and the Minister of the Municipal Affairs.Trade and Commerce of the Province of Quebec to obtain dissolution of its charter and its cancellation from a date to be fixed by them.Quebec, 12th May 1950.A.ÉMILE BEAUVAIS, 27514-u Secretary.Selecta Girdle Inc.NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies Act, as amended, \"Selecta Girdle Inc.\" does hereby give notice that it will apply to the Honourable the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter, secure the cancellation thereof, and fix the date upon which the company shall be dissolved.Quebec, P.Q.Mav 11, 1950.PIERRE AMYOT, 27515 Secretary.Notice is hereby given that \"Inter-American Fisheries Limited\", incorporated by letters patent bearing date May 1, 1947, will apply to the Attorney General and to the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, pursuant to the provisions of the Quebec Companies Act, for leave to surrender its charter and its cancellation at such date as it may please the said Attorney General and Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, to determine.Dated at Montreal, this 9th day of May, 1950.MARCEL PICHÊ, Secretary of 27538 \"Inter-American Fisheries Limited.Département des Affaires municipales I/c soussigné donne avis que, tel (pie demandé par une résolution du 1er mai 1950 du conseil de la municipalité de Sainte-Félicité, comté dc L'Islet, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a autoiisé, en date du 12 mai 1950, (pie les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 12 mai 1950.Le Ministre des Affaires municipales, 27516-0 BONA DUSSAULT.Department of Municipal Affairs The undersigned gives notice that, as requested by a resolution of May I, 1950, of the Council of the municipality of Sainte-Félicité, county of L'Islet, and pursuant to the provisions of article 130 of the Municipal Code he has authorized, under date of May 12, 1950, that all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said Corporation, save those required in the Quebec Official Gazette, be made, in future, in the French language only.The present notice is published in conformity w ith article 131 of the Municipal Code (10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, May 12, 1950.BONA DUSSAULT, 27510 Minister of Municipal Affairs. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1437 Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 1er mai 1950 du conseil de la paroisse de Ste-Flore, comté «le St-Maurice, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a autorisé, eu date du 12 mai 1950, que les publications dc tous les avis publies, règlements, résolutions ou ordres «le la dite corporation, sauf celles requises dans la (\u2022HZ'Ile officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 «lu C«m1c municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 12 mai 1950.Le Ministre des Affaires municipales, 27516-0 BONA DUSSAULT.Département de l'Instruction publique N° 035-50 Québec, le 10 mai 1950.Demande est faite d'ériger en une municipalité scolaire distincte, pour les catholiques seulement, sous le nom «le \"La municipalité scolaire catholique Des Boules\", dans le comté «le Matane, le territoire ci-dessous décrit, savoir: a) Les lots suivants, tous inclusivement du canton «le McNider, qui seront détachés de la municipalité scolaire «le Baic-des-Sablcs, savoir: 60 à 88 rang I; 90 à 127 rang U; 251 à 285 rang 111; 399 à 444 rang IV; 542 à 582 rang V.b) Les lots suivants, tous inclusivement «le la Seigneurie «le Métis, qui seront détachés dc la municipalité scolaire de Kempt, dans le comté de Matapédia, savoir: 070 à 097 rang V; dans le rang VI, le territoire compris entre la ligne separative de ladite Seigneurie «le Métis et du canton de McNider et la continuation, dans ledit rang dc la ligne separative des lots 696-A et 697-A «lu rang V.c) Les lots suivants, tous inclusivement de la Seigneurie de Métis, qui seront détachés de la municipalité scolaire de St-Octave savoir: 303 et 303-A rang II; 376 à 384 rang III; 655 à 675 rang IV.«/) fx; territoire suivant, qui sera détaché de la municipalité scolaire «le Métis, et qui sera délimité comme suit, savoir: Partant d'un point situé sur la rive du fleuve Saint-Laurent, à la ligne de division entre les lots 86, 88 et 90 et en se dirigeant dans une direction est jusqu'à l'intersection de la ligne de division entre les lots 58 et 00 «lu rang I du canton McNider, puis dans une direction sud-ouest en suivant la ligne separative entre les rangs I et II dudit canton, jusqu'à la ligne de division entre ledit canton et la Seigneurie de Métis, puis en suivant cette ligne jusqu'au rang IV «le la Seigneurie de Métis et en suivant la ligne separative «les rangs III et IV dans une direction sud-ouest jusqu'à la ligne de division entre les lots 375 et 370, puis en suivant ladite ligne jusqu'au rang II et de ce point, dans une direction sud-ouest en suivant la ligne separative des rangs II et III jusqu'à la ligne de division «les lots 303 et 304 et en suivant cette ligne dans une direction nord-ouest jusqu'au rang I, puis dans une direction sud-ouest en suivant une ligne brisée séparant les rangs I et II de la Seigneurie «le Métis, jusqu'à l'intersection de la ligne séparant les lots 87 et 94 «lu rang I et en suivant dans une direction nord, ladite ligne jusqu'à la rive «lu fleuve Saint-Laurent, point «le départ.Le Surintendant de l'Instruction publique, 27437-19-2-0 O.-J.DESAULNIERS.The undersigned gives notice that, as requested by a resolution of May 1, 1950, the Council of the Parish of Ste-Flore, county of St-Maurice, and pursuant to the provisions of article 130 of the Municipal Code he has authorized, under date of May 12, 1950, that all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said Corporation, save those required in the Quebec Official Gazette, be made, in future, in the French language only.The present notice is published in conformity with article 131 of the Municipal Code (10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec.May 12, 1950.BONA DUSSAULT, 27516 Minister of Municipal Affairs.Department of Education No.635-50 Quebec, May 10, 1950.Application is made to erect into a separate school municipality, for Catholics only, under the name of \"The Catholic School Municipality of Des Boules\", in the county of Matane, the territory described as follows, to wit: a) The following lots, all inclusively of the township McNider, to be detached from the school municipality of Baic-des-Sables, to wit: 60 to 88 range I; 96 to 127 range II; 251 to 285 range III; 399 to 444 range IV; 542 to 582 range V.b) The following lots, all inclusively of the Seigniory of Metis, to be detached from the school municipality of Kempt, in the county of Matapédia, to wit: 676 to 697 range V; in range VI, the territory comprised between the division line of the Seigniory of Metis and the township McNider and the continuation, in the said range of the division line of lots 696-A and 697-A of range V.c) The following lots, all inclusively of the Seigniory of Metis, to be detached from the school municipality of St-Octave, to wit: 303 and 303-A range II; 376 to 384 range III; 655 to 675 range IV.d) The following territory, to be detached from the school municipality of Métis, and to be bounded as follows, to wit: Starting from a point situate on the shore of the Saint Lawrence river, at the division line between lots 86, 88 and 90 and running eastward as far as the intersection of the division line between lots 58 and 60 of range I of the township McNider, thence in a southwesterly direction following the division line between ranges I and II of the said township, as far as the division line between the said township and the Seigniory of Metis, thence following the said line up to range IV of the Seigniory of Metis and following the division line of ranges III and IV in a southwesterly direction as far* as the division line between lots 375 and 376, thence following the said line as far as range II and from this point, in a southwesterly direction following the division line of ranges II and HJ as far as the division line of lots 303 and 304 and following the said line in a northwesterly direction up to range I, thence in a southwesterly direction following a broken line separating ranges I and II of the Seigniory of Métis, as far as the intersection of the line separating lots 87 and 94 of range I and following in a northerly direction, the said line as far as the shore of the Saint Lawrence river, the starting point.O.-J.DESAULNIERS, 27437-19-2 Superintendent of Education. 1438 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO mai 19Ô0, Tomt 82, N° 20 N° 720-50 Québec, le 10 mai 1950.Demande est faite que le nom de la municipalité scolaire de \"Trait-C'arré-de-Charlcsbourg\", dans le comté dc Québec, soit changé en celui de \"La municipalité scolaire de la Ville dc Char-lesbourg\", dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 27430-19-2-u O.-J.DESAULNIERS.N° 389-50 Québec, le 15 mai 1950 Demande est faite d'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de Saint-Edouard, dans le comté de Maskinongé, le territoire ci-dessous décrit, savoir: 1° Les lots ou parties de lots du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Justin, qui seront détachés de la municipalité scolaire dc la paroisse de Saint-Justin; a) partie nord-ouest du deuxième rang, depuis le lot N° 329 jusqu'au lot N° 340 inclusivement; b) la partie nord-ouest du troisième rang depuis le lot N° 347 jusqu'au lot N° 371 inclusivement; c) la partie nord-ouest du quatrième rang depuis le lot N° 539 jusqu'au lot N° 570 inclusivement.2° Les lots ou parties de lots suivants, du cadastre officiel de Saint-Ursule, qui seront détachés de la municipalité scolaire de Saint-Ursule: a) partie du lot X° 4 et les lots Nos 5 et 6 de la réserve de Atkinson du cadastre officiel de la paroisse de St-Didacc; b) depuis le lot N° 10 jusqu'au lot N° 20 inclusivement du 1er rang du cadastre officiel de la paroisse de St-Didacc; c) depuis le lot N° 500 jusqu'au lot N° 510 de la partie nord-ouest de la concession de Sainte-Louise, du cadastre officiel de la paroisse dc Saint-Ursule; rté de la cité «le Quél>ec à la cité de Montréal, province de Qucc.Copie conforme certifiée «lu règlement spécial \"M\" adopté par les directeurs de la compagnie \"Cantin Sales Agencies.Ltd.\" à leur assemblée tenue le 19 avril 1950, et approuvé et sanctionne par le vote d'au moins les «leux tiers en valeur «les actions représentées par les actionnaires présents à une assembh'-e g«'iiérale spéciale «les actionnaires «le ladite compagnie convoquée pour le consi«l«'rer et tenue le même jour.Montréal.P.Q., 3 mai 1950.(Sceau) Ix> Secrétaire.27517 F.C COPE.Canada, province de Québec, district de Montréal He: Joseph Lorenzo Guay Incorporée AVIS Avis est donné que la Compagnie \"Joseph Lorenzo Guay Incorporé-c\" constituée en corporation par Lettres Patentes en date «lu 2 septembre 1948.et enregistrées le 8 septembre 1948, telles qu'amendées par Lettres Patentes Supplémentaires en «late «lu 7 février 1949.et enregistrées le 11 février 19-19, et ayant son bureau principal «lans la ville «le Montréal, a établi son bureau au numéro 3730, de la rue Courtray, à Montréal.A compter r the purchase of 860,000 of bonds «>f the municipal corporation of the Village of Normandin, dated the 1st of May, 1442 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai 1950, Tome 82, N° 20 et remboursables par séries du 1er mai 1951 au 1er mai 19G5 inclusivement, avec intérêts à un taux n'exédant pas 33^% par année, payable semi-annucllement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.L'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant : Tableau d'amortissement\u2014$60,000\u201415 ans Année Capital 1er mai 1951.$3,000.00 1er mai 1952 .3,000.00 1er mai 1953 .3,500.00 1er mai 1954 .3,500.00 1er mai 1955.3,500.00 1er mai 1950 .3,500.00 1er mai 1957 .4,000.00 1er mai 1958 .4,000.00 1er mai 1959 .4,000.00 1er mai I960.4,500.00 1er mai 1901 .4,500.00 1er mai 1902 .4,500.00 1er mai 1903 .4,500.00 1er mai 1904 .5,000.00 1er mai 1905.5,000.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à St-Félicien, comté dc Roberval.Ces obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant du total de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi le G juin 1950, à 8 heures p.m., à la salle municipale de Normandin.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Normandin, comté dc Roberval, ce 13 mai 1950.Le Secrétaire-trésorier, HENRI BERNARD, Normandin, 27527-0 (Comté de Roberval), P.Q.1950, and redeemable serially from the 1st of May, 1951 to the 1st of May 1965 inclusive, with interest at a rate not exceeding 3j^% per annum, payable semi-annually the 1st of May and 1st of November of each year.Interest may be the same for the total issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tabic of Rédemption\u2014$60,000\u201415 years Year Capital May 1st, 1951.$3,000.00 May 1st, 1952.3,000.00 May 1st, 1953.3,500.00 May 1st, 1954.3,500.00 May 1st, 1955.3,500.00 May 1st, 1956.3,500.00 May 1st, 1957.4,000.00 May 1st, 1958.4,000.00 May 1st, 1959 .4,000.00 May 1st, 1960.4,500.00 May 1st, 1961.4,500.00 May 1st, 1962.4,500.00 May 1st, 1963.4,500.00 May 1st, 1964.5,000.00 May 1st, 1965.5,000.00 Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at St-Félicien, county of Roberval.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest payment date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec 1941; however, if such redemption be partial the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday the 6th of June, 1950, at 8 o'clock P.M., in the'Municipal Hall of Normandin.The council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Normandin, County of Roberval, this 13th day of May, 1950.HENRI BERNARD, Secretary-Treasurer, Normandin, 27527 (County of Roberval), P.Q.Province de Québec VILLE DE COATICOOK s (Comté de Stanstead) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Romuald Du mont, secrétaire-trésorier, Casier postal 150, Coaticook, comté de Stanstead, jusqu'à 7.30 lires p.m., mardi le 6 juin 1950, pour l'achat d'une émission de 860,000.00 d'obligations de la ville de Coaticook, datées du 1er septembre 1918 et remboursables par séries, en 18 ans, du 1er septembre 1951 au 1er septembre 1968 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3%% par année, payable semi-annucllement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.L'intérêt peut être le même Province of Québec TOWN OF COATICOOK (County of Stanstead) Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tender for bonds\" will be received by the undersigned, Romuald Dumont.Secretary-Treasurer, P.O.Box 150, Coaticook, county of Stanstead, up to 7.30 o'clock P.M.on the 6th of June, 1950, for the purchase of bonds to the amount of $60,000.00, of the Town of Coaticook, dated the 1st of September, 1948 and redeemable serially over a period of eighteen years, from the 1st of September 1951 to the 1st of September 1968 inclusively, with interest at a rate not exceeding 3]^% per annum, payable semi-annually the 1st of March and 1st of September of each year.The interest may be 1144 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 20 mai 1950, Tome 82, N° 20 Tableau d'amortissement\u2014$60,000\u201412 ans Année Capital 1er mai 1951.S5.000.00 1er mai 1952 .5,000.00 1er mai 1953 .5,000.00 1er mai 1954 .5,000.00 1er mai 1955.5,000.00 1er mai 1956 .5,000.00 1er mai 1957.5,000.00 1er mai 1958.5,000.00 1er mai 1959.5,000.00 1er mai 1900 .5,000.00 1er mai 1961 .5,000.00 1er mai 1962 .5,000.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Ville-Marie, comte de Témiscamingue.Les obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant total dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue dimanche le 4 juin 1950, à 2 heures p.m., à l'école centrale.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Angliers, comté dc Témiscamingue, ce 16 mai 1950.Le Secrétaire-trésorier, P.-A.DULUDE.Angliers, comté de Témiscamingue, 27534-0 P.Q.Table of Redemption\u2014960,000\u201412 years Year Capital May 1st, 1951.$5,000.00 May 1st, 1952 .5,000.00 May 1st, 1953.5,000.00 May 1st, 1954 .5,000.00 May 1st, 1955.5,000.00 May 1st, 1956.5,000.00 May 1st, 1957 .5,000.00 May 1st, 1958 .5,000.00 May 1st, 1959.5,000.00 May 1st, 1900.5,000.00 May 1st, 1901.5,000.00 May 1st, 1902.5,000.00 Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montréal, Quebec or at Ville-Marie, county of Témiscamingue.The bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest payment date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1911; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Sunday the 4th day of June, 1950, at 2 o'clock P.M.in the ('entrai School.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Angliers, county of Témiscamingue, this 16th dav of May, 1950.P.A.DULUDE, Sccretary-Trca.su rer.Angliers, county of Témiscamingue, 27534 P.Q.Ventes \u2014 Loi de faillite Canada, Province de Québec, district de Saint-François, Bedford, No.4 Cour supérieure (en matière dc faillite).Dans l'affaire de Jean-Paul Provencher, industriel, 532 rue St-Charles Nord, Granby, dans le district de Bedford, Province de Québec, Canada, cédant autorisé.Avis public est par les présentes donné que les immeubles désignés comme suit: 1° Un emplacement situé en la Cité de Granby, sur le Côté Ouest de la rue St-Charles Nord, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Canton maintenant Cité de Granby, sous le numéro cinquante six de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent vingt-quatre (724-56), mesurant soixante pieds de largeur sur cent treize pieds et demi de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, avec bâtisses en construction y érigées, circonstances et dépendances, et les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées.2° Un emplacement situé en la Cité de Granby, sur le côté Ouest de la rue St-Charles Nord, Sales \u2014 Bankruptcy Act Canada, Province of Quebec, District of Saint Francis, Bedford, No.4, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of Jean Paul Provencher, industrialist, 532, St-Charles-street North Granby, in the district of Bedford, Province of Quebec, Canada, Authorized Assignor.Public notice is hereby given that the immovables described as follows: 1.An emplacement situate in the City of Granby, on the west side of St-Charles street North, known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the township now City of Granby, as number fifty-six of the official subdivision of original lot seven hundred and twenty-four (724-56), measuring sixty feet in width by one hundred and thirteen feet and one half in depth, English measure and more or less, with the buildings under construction thereon erected, circumstances and dependencies, and the active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto.2.An emplacement situate in the City of Granby, on the west side of St-Charles street QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1445 connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Canton maintenant Cité de Granby, comme étant le lot numéro cinquante sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent vingt-quatre (724-57), mesurant soixante pieds de largeur sur cent treize pieds et demi de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, avec bâtisses en construction y érigées, circonstances et dépendances, et les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées; Seront vendus séparément suivant un jugement de la Cour Supérieure pour le District de St-François\", Bedford, en matière de faillite, rendu le cinq avril mil neuf cent cinquante, portant le N° 967 des dossiers de la dite Cour, aux Enchères Publiques, de manière à donner à cette vente l'effet du décret, conformément aux prescriptions de l'Article Quarante-cinq de la loi de faillite, à la porte de l'Église Sainte-Famille de Granby, MERCREDI le QUATORZIEME jour du mois de JUIN mil neuf cent cinquante à ONZE heures de F Avant-midi (heure avancée de l'Est).Condition de vente 10% comptant, la balance sous trois jours.Pour informations et cahier des charges s'adresser au soussigné.C mai 1950.Le Syndic, ALBERT LAMARRE.Du Bureau de Lamarre & Inns, 10, Est rue St-Jacques, Montréal.27412-19-2-0 Canada, Province de Québec, District d'Abi-tibi.Cour Supérieure (En matière dc faillite).Dans l'affaire de Lionel Lambert, épicier-boucher, Val D'Or, P.Q., cédant autorisé.Avis public est, par les présentes, donné que l'immeuble désigné comme suit: Le lot numéro trente-sept de la subdivision (lu lot originaire numéro soixante et un (01-37) dans le Rang Huit, aux plan et livre de renvoi officiels pour le Canton Duhuisson, avec bâtisses y érigées, à distraire cependant du dit lot, la lisière de terre cédée à la Ville dc Val d'Or, pour trottoirs, ainsi que la lisière cédée à Alfred Dou-ville.par acte enregistré au bureau d'enregistrement du Comté d'Abitibi, sous N° 26527, mesurant cette dite lisière six-dixièmes de pied de largeur sur quarante pieds de profondeur à partir de la ligne de front dc la bâtisse du dit A.Douville, érigée sur le lot voisin, laquelle ligne (le front est elle-même à dix pieds de la ligne de iront du dit lot.Avec toutes servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, y attachées, et sujet à toutes les restrictions imposées au cédant autorisé par ses titres.Sera vendu suivant un jugement de la Cour Supérieure pour le District d'Abitibi, en matière de faillite, rendu le vingt mars mil neuf cent cinquante, portant le N° 278F des dossiers dc la dite Cour, aux enchères publiques, de manière à donner à cette vente l'effet du décret conformément aux prescriptions de l'Article 45 de la Loi de Faillite, au Bureau du Shérif dudit District d'Abitibi.sit\u201eé à Amos.JEUDI, le VINGT-DEUXIEME jour de JUIN 1950, à TROIS heures dc l'après-midi (heure avancée de l'Est).Conditions de vente, dix pour cent (10%) comptant, la balance sous trois jours.North, known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the township now City of Granby, as being lot number fifty-seven of the official subdivision of original lot number seven hundred and twenty-four (724-57), measuring sixty feet in width by one hundred and thirteen feet and one half in depth, English measure and more or less, with the buildings under construction thereon erected, cuircumstances and dependencies, and the active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto; To be sold separately, according to a judgment of the Superior Court for the District of St.Francis, Bedford sitting in Bankruptcy, rendered the fifth day of April, one thousand nine hundred and fifty, bearing No.967 of the records of the said Court, by public auction, so as to give the said sale the effect of a Sheriff's sale, pursuant to the provisions of Section forty-five of the Bankruptcy Act, at the church door of Sainte-Famille de Granby, on WEDNESDAY, the FOURTEENTH day of the month of JUNE, one thousand nine hundred anf fifty, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Eastern Daylight Saving Time).Condition of sale 10% cash, the balance within three days.For information and list of charges, apply to the undersigned.May 6, 1950.ALBERT LAMARRE, Trustee.Of the Office of Lamarre & Inns, 10 St.James street East, Montreal 27412-19-2 Canada, Province of Quebec, district of Abi-tibi.Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of Lionel Lambert, grocer-butcher, Val d'Or, P.Q.Authorized Assignor.Public Notice is hereby given that the immovable described as follows: Lot number thirty-seven of the subdivision of original lot number sixty-one (01-37) in Range eight, on the official plan and in the book of reference for the Township Dubuisson\u2014with buildings thereon erected, to be deducted, however, from said lot, the strip of land assigned to the Town of Val d'Or, for sidewalks, and also the strip assigned to Alfred Douville, by deed registered at the Registry Office for the County of Abitibi, under No.26527, the said strip measuring six tenths of a foot in width by forty feet in depth, starting at the front line of the building of said A.Douville, erected on the neighbouring lot.the said front line is itself at ten feet from the front line of said lot.With all the active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto, and subject to all restrictions imposed on the authorized assignor by his title deeds.To be sold, following a judgment of the Superior Court for the district of Abitibi, (Sitting in Bankruptcy), rendered the twentieth day of March, one thousand nine hundred and fifty, bearing No.278F of the records of the said Court, by public auction, so as to give the said sale the effect of a Sheriff's sale, pursuant to the provisions of section 45 of the Bankruptcy Act, at the Sheriff's Office for the district of Abitibi, situate at Amos, on THURSDAY the TWENTY-SECOND day of JUNE, 1950, at THREE o'clock in the afternoon (Eastern Daylight Saving Time).Conditions of sale, ten per cent (10%) cash, the balance within three days. 1446 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai I960, Tome 82, N° 20 Pour informations et Cahier des Charges, For information and list of charges, apply to s'adresser au soussigné.the undersigned.11 mai 1950.Mav 11, 1950.Le Syndic.ALBERT LAMARRE, ALBERT LAMARRE.Trustee.Du Bureau de: Office of: Lamarre & Inns, Lamarre & Inns, 10 est, rue St-Jacques, Montréal.27520-20-2-o 10 St.James street East, Montreal.27520-20-L' AVIS DE VENTE Province dc Québec, district de Montréal, Cour supérieure, N° 230 (\"En faillite\").Dans l'affaire dc: Princeville Woodcraft Limited, manufacture, corps politique et incorporé, ayant son siège social dans la ville de Thetford Mines, district d'Arthabaska, failli.Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant savoir: Désignation: Un morceau dc terrain situé au village dc Princeville, comté d'Arthabaska, dans la province de Québec, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels, pour le village dc Princeville, comme étant le lot numéro un de la subdivision du lot numéro deux cent trente-six (N° 230-1) et borné ledit morceau de terrain comme suit: savoir: En front au nord-ouest par le terrain du chemin de fer Canadien National Railway, en arrière au sud-est par la partie non-subdi visée du dit lot numéro deux cent trente-six appartenant à Lorenzo Roux, d'un côté à l'est par une autre partie de la partie non-subdivisée du dit lot numéro deux cent trente-six à distance de quatre-vingt-douze pieds (92') de la ligne du lot numéro quatre-vingt-huit du dit cadastre, et de l'autre côté à l'ouest par le lot numéro deux cent trente sept du dit cadastre appartenant à Henri Turgeon.Avec et y compris un droit de passage de toutes sortes à la continuation de la rue St-Georges pour communiquer à la dite rue au terrain ci-dessus décrit, ce droit de passage s'exerçant sur une partie non-su bdi visée du lot numéro deux cent trente six (N° 236) du dit cadastre officiel du village de Princeville, le tout conjointement avec les autres qui peuvent y avoir droit en vertu de leurs titres.Avec toutes les bAtisses dessus érigées, circonstances et dépendances, ainsi que le tout se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées au dit immeuble.Sera vendu à la porte dc l'église paroissiale dc Princeville, Comté d'Arthabaska à ONZE heures de l'avant-midi (heure solaire), MERCREDI le VINGT ET UN JUIN 1950.Cette vente est faite en vertu d'un jugement rendu par le Régistraire «lu greffe des faillites à Montréal, le llième jour de mai 1950, et suivant les dispositions de l'article 45 dc la Loi de Faillite, et avec l'effet du décret.Conditions: Comptant.En plus du prix d'acquisition, l'acquéreur devra payer les droits du gouvernement de 2%% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges, s'adresser au soussigné.Montréal, le 15 mai 1950.Le Syndic, Bureau de : CLAUDE PÉRRAS.Perras & Pcrras, 4 Notre-Dame est, Montréal.27529-20-2-o NOTICE OF SALE Province of Quebec, district of Montreal.Superior court.No.230 (Sitting in Bankruptcy).In the matter of: Princeville Woodcraft Limited, factory, a body politic and corporate, having its head office in the Town of Thetford Mines, district of Arthabaska, insolvent.Public notice is hereby given that the following immovable to wit: Description: A parcel of land situate in the village of Princeville, county of Arthabaska, in the Province of Quebec, known and designated on the official plan and in the book of reference for the village of Princeville, as being lot number one of the subdivision of lot number two hundred and thirty-six (No.236-1), the said parcel of land being bounded as follows: to wit: In front on the northwest by the land of the Canadian National Railway line, in rear to the southeast by the unsubdivided part of said lot number two hundred and thirty-six belonging to Lorenzo Roux, on one side, to the east, by another part of the unsubdivided part of said lot number two hundred and thirty-six at a distance of ninety-two feet (92') from the line of lot number eighty-eight of said cadastre, and on the other side, to the west, by lot number two hundred and thirty-seven of said cadastre belonging to Henri Turgeon.With and including a right of way of all kinds in the continuation of St-Gcorges street to communicate to the said street and to the land above described, the said right of way being exercised over an unsubdivided part of lot number two hundred ami thirty-six (No.236) of said official cadastre for the village of Princeville.the whole jointly with others who may have a right thereto under the terms of their title-deeds.With all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and as the whole presently subsists, with the active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to the said immovable.To be sold at the parochial church door of Princeville, county of Arthabaska, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Standard Time), on WEDNESDAY the TWENTY-FIRST day of JUNE, 1950.The said sale is made pursuant to a judgment rendered by the Registrar of the Bankruptcy Office at Montreal, on the 11th day of May.1950, and in conformity with the provisions of section 45 of the Bankruptcy Act, having the effect of a Sheriff's sale.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the purchaser shall pay the Government dues of 2^% according to Law.For further information and list of charge.*, apply to the undersigned.Montreal.Mav 15, 1950.CLAUDE PERRAS, Office of: Trustee.Pcrras & Perras, 4 Notre-Dame East, Montreal.27529-20-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 20th, 1950, Vol.82, No.20 1447 Province de Québec, district de Juliette, Cour Supérieure (En matière de faillite), N° 394, lu Re: Charles Moranville, homme d'affaires, de la paroisse de Saint-Félix de Valois, district de Juliette, cédant-autorisé.Avis est par les présentes donné que jeudi, le VINGT-DEUXIEME jour de JUIN 19Ô0, à DIX heures de l'avant-midi, à la porte de l'église paroissiale de Saint-Félix de Valois, district de Juliette, sera vendu, par encan public, au plus haut et dernier enchérisseur, l'immeuble suivant cédé par le cédant-autorisé, en cette cause, savoir: l'n terrain situé dans la concession Castle Hill & Autray, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro trois cent soixante-cinq (P.305) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Félix de Valois, borné au sud-ouest par le chemin public où il contient cinq cents pieds, au nord-est par la terre dc Dame Gcorgina Glcnny, Ve John A.Stevens, qui fait aussi partie du lot numéro trois cent soixante cinq (P.305), où il contient aussi cinq cents pieds, au nord-ouest par le terrain de Adélard Comtois où il contient un arpent, et au sud-est par le terrain de llormisdas Rainvillc où il contient aussi un arpent, le tout mesure anglaise et plus ou moins, ces deux derniers terrains faisant aussi partie du lot N° 305; bâti d'une maison, poulailler et dépendances.Avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées à l'immeuble ci-dessus décrit.Conditions dc la vente: Il sera exigé tie tout offrant ou enchérisseur une somme représentant 10% «le son offre ou enchère; Cette vente faite d'après les articles 44 et 45 de la Loi dc Faillite équivaut à une vente faite par le Shérif.13 mai 1950.Le Syndic-autorisé, PAUL JOLICOEUR, 27521-20-2-O 223 Gaspard-Sud.Province of Quebec, District of Joliette, Superior Court (Sitting in Bankruptcy), No.394.In Re: Charles Moranville, business man, of the paiish of Saint-Félix de Valois, district of Joliette, Authorized Assignor.Notice is hereby given that on THURSDAY, the TWENTY-SECOND day of JUNE, 1950, at TEN o'clock in the forenoon, at the parochial church door of Saint-Félix de Valois, district of Joliette, there will be sold, by public auction, to the highest and last bidder, the following immovable assigned by the Authorized Assignor, in this case, to wit: A lot of land situate in the Castle Hill & Autray concession, known and designated as forming part of lot number three hundred and sixty-five (Pt.305) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St-Félix de Valois, bounded on the southwest by the public road where it measures five hundred feet, on the northeast by the land of Dame Gcorgina Glenny, widow of John A.Stevens, which also forms part of lot number three hundred and sixty-five (Pt.305), where it also measures five hundred feet, on the northwest by the land of Adélard Comtois where it measures one arpent, and on the southeast by the land of Hormisdas Rain-ville where it also measures one arpent, the whole English measure and more or less, the two last mentioned lots of land also form part of lot No.305; with a house, hen-house and dependencies thereon erected.With the active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to the immovable above described.Conditions of sale: An amount representing 10% of his offer or bid will be exacted from each and every bidder; The said sale shall be made pursuant to sections 44 and 45 of the Bankruptcy Act giving the effect of a Sheriff's sale.May 13, 1950.PAUL JOLICOEUR, Authorized Trustee, 27521-20-2 223 Gaspard South.Vente pour taxes Province de Québec Iles-de-la-Madeleixe Avis public est par le présent donné par le soussigné, F.-A.Painchaud, Secrétairc-Tréso-rit r du Conseil de Comté des Iles de la Madeleine, que les immeubles ci-dessus mentionnés, seront vendus à l'enchère publique, au Palais de justice a llavre-Aubert, MERCREDI le CINQUIEME jour de JUILLET, Mil neuf cent cinquante, à DIX heures de l'avant midi, pour taxes municipales et scolaires ducs sur ces immeubles, à moins (pi'elles ne soient payées avec les frais avant la vente, savoir: Dans la Municipalité de Havre-aux-Maisons Comme appartenant à Honoré Arscneau et \u2022 tant occupé par Théofrcd Arseneau, un lot de terre connu au cadastre de l'Ile Alright dans les Iles de la Madeleine, comme faisant partie de la subdivision 400 du lot 209, contenant un acre en superficie avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: $2.90; taxes scolaires: SI 1.59.Sale for Taxes Province of Quebec Magdalen Islands Public notice is hereby given by the undersigned F.-A.Painchaud, Secretary-Treasurer of the County Council of Magdalen Islands, that the immoveables hereafter mentioned will be sold by public auction, at the Court House, at Havre-Aubcrt, on WEDNESDAY the FIFPH day of JULY Nineteen hundred and fifty, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal and school taxes due upon these immoveables, unless the same be paid with cost before the sale, to wit: In the Municipality of Havre-aux-Maisons As belonging to Honoré Arseneau and being occupied by Théofred Arseneau, one lot of land known in the Cadastre of Alright Island, in the Magdalen Islands, as forming part of the subdivision 400 of lot 209 containing one acre in area, with buildings thereon erected.Municipal taxes: $2.96; School taxes: SI 1.59. 1448 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 mai JOÔO, Tome 82, N° 20 Comme appartenant à Joseph Poirier et étant occupé pur Krncst Poirier, un lot dc terre connu au même cadastre, comme partie du lot X'° 30, contenant six acres et trois quarts, avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: 85.90; taxes scolaires: 820.S5.Comme appartenant à Joseph Poirier et étant occupé par Mme Daniel Poirier, un lot de terre connu au même cadastre, connue partie du lot N° 36, contenant six acres et trois quarts, avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: S2.S0; taxes scolaires: 811.93.Dans la municipalité de (Juande Entrée Comme appartenant à Dame Emilie Jomphc ou semblant lui appartenir, deux lots de terre connus au cadastre de l'Ile Coffin, comme subdivision 165 du lot 47 contenant 20 acres et subdivision 243 du même lot 47 contenant 10 acres, avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: 80.40; taxes scolaires: $28.95.Donné à Havre-Aubert, I.M.ce dixième jour de mai 1950.\\a Secrétaire-trésorier du Conseil de Comté des Iles de la Madeleine, 27522-20-2-o P.-A.PAINCHAUD.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUCE Fieri Facias de Terris Dans la Cour Supérieure District de Beaucc St-Josephde Beauce, /DMILE FLEURY.de-à savoir: < mandeur, St-Mala- N° 20,054 (.chic; vs OVILA LA-CASSE, défendeur, St-Malachic.A savoir: les lots N° 71, 72 du cadastre pour la paroisse de St-Malachie (dans le Sème rang, canton Frampton), ainsi (pie les bâtisses, les circonstances et dépendances, tel (pie le tout est actuellement avec les servitudes actives et passives, sans exception ni réserve.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale, en la paroisse de St-Malachic, le VINGT SIXIEME jour de JUIN prochain à DIX heures du matin (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, J.-S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, 15 mai 1950.275_30-20-2-o [Première insertion: le 20 mai 1950] (Seconde insertion: le 3 juin 1950] BEDFORD Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, ( CLAYTON BALL, Province de Québec, ) ^ commerçant de la District de Bedford, ) paroisse de St-Paul d'Ab-N° 3094 { botsford, district de St-Hyacinthe, demandeur; vs OVILA HARDY, commerçant de la cité dc Granby, et ALFRED BELANGER, commerçant du Canton de Granby, dans le district de Bedford, défendeurs.Comme appartenant aux défendeurs: Lopin de terre faisant partie du lot N° 735 au plan et livre de renvoi officiel du Canton de As belonging to Joseph Poirier and being occupied by Ernest Poirier one lot of land known in the same cadastre as part of lot 30, containing six acres and three quarters with buildings thereon erected.Municipal taxes: 85.90; School taxes: 820.85.As belonging to Joseph Poirier and being occupied by Mrs.Daniel Poirier, one lot of land known on the same cadastre as part of lot 3li containing six acres and three quarters, with buildings thereon erected.Municipal taxes: 82.80; School taxes: 811.93.In the Municipality of Grande Entrée As belonging to Dame Emilie Jomphe or supposed to belong to her, two lots of land known on the cadastre of Coffin Island, as subdivision 165 of lot 47 containing 20 acres and subdivision 243 of the same lot 47 containing 10 acres, with buildings thereon erected.Municipal taxes: S6.40; School taxes: 828.95.Given at Havre-Aubert.M.I.this tenth day of May 1950.F.A.PAINCHAUD.Secretary-Treasurer of the County 27522-20-2-o Council of Magdalen Islands.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LAND and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUCE Fieri Facias de Tern's In the Superior Court District of Beauce St-Joseph dc Beauce./\"DMILE FLEURY to wit:
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.