Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 juin 1950, samedi 3 (no 22)
[" Tome 82, N° 22 1523 Vol.82, No.22 Drapeau delà province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubushed by the provincial govern ment) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 3 juin 1950 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 3rd, 1950 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to : The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 1524 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin I960, Tome 82, N° 22 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 26G lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement : S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per a,gate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first inseition; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439 \u20141-52 Lettres patentes Bouchard & Bourret Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize avril 1950, constituant en corporation: Ernest .William Mockridge, gérant, de St-Lam-bert, William Patrick Creogh, commis, de Ville Mont-Royal, et Clifford George Meek, comptable, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeubles, de construction et de développement, sous le nom de \"Bouchard & Bourret Ltée\", avec un capital de §500,000.divisé en 4,000 actions privilégiées de SI00 chacune et 1,000 actions orinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drum-mondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le treize avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27018-o L.DÉSILETS.Letters Patent Bouchard & Bourret Ltde Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of April, 1950, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, of St-Lambert, William Patrick Creagh, clerk, of the Town of Mount Royal, and Clifford George Meek, accountant, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following'purposes: To carry on the business of a real estate, building and development company, under the name of \"Bouchard & Bourret Ltée\", with a capital stock of S500.000 divided into 4,000 preferred shares of S100 each and 1,000 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of April.1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol 82, No.22 1525 Canadian Arts Renovation Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du cinq avril 1950, constituant en corporation: Jean Geolïrion, avocat, de la cité d'Outremont, Lorraine Séguin et Gisèle Dionne, sténographes, lilies majeures, toutes deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants: Exercer le commerce de décorateurs, drapiers, marchands de bibelots et d'oeuvres d'art, sous le nom de \"Canadian Arts Renovation Incorporated\", avec un capital de $5,000 divisé en 100 actions de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1950.L'Assistant-procureur général, 2701S-o L.DÉSILETS.Canasta Café Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1950, constituant en corporation: Louis-Philippe Gagnon, conseiller en Loi du Roi, Françoise Savard, secrétaire, et Marcel Landry, étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurant et café, sous le nom de \"Canasta Café Inc.\", avec un capital de §40,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 123 ouest, rue St-Jacques, ch.322, Montréal, distiict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27018-o L.DÉSILETS.Continental Housing Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente et un mars 1950, constituant en corporation: Timothy Patrick Slaterry, conseil en loi du Roi, de Westmount, Laurent Edmond Bélanger, conseil en loi du Roi, de Mont-Royal, William Allen Grant, procureur, Kathleen Mackenzie, secrétaire, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal et Jeannette Bissonnctte, secrétaire, fille majeure, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, d'améliorations et de placements, sous le nom de \"Continental Housing Corporation\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 8,000 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de quarante mille dollars (840,000).Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27618 L.DÉSILETS.Canadian Arts R< novation Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, tewing date the fifth day of April, 19i!0, incorporating: Jean Geoffrion, advocate, of the city of Outremont, Lorraine Séguin and Gisèle Dionne, stenographers, spinsters, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as decorators, drapers, dealers in fancy goods and works of art, under the name of \"Canadian Arts Renovation Incorporated\", with a capital stock of 85,000.divided into 100 shares of 850 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Canasta Café Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Gouvcrnor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1950, incorporating: Louis-Philippe Gagnon, King's Counsel, Françoise Savard, secretary, and Marcel Landry, law student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the restaurant and café business, under the name of \"Canasta Café Inc.\", with a capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 132 St.James Street West, Room 322, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Continental Housing Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March, 1950, incorporating: Timothy Patrick Slaterry, King's Counsel, of Westmount, Laurent-Edmond Bélanger, King's Counsel, of Mount Royal, William Allen Grant, solicitor, Kathleen Mackenzie, secretary, spinster, both of the City of Montreal, and Jeannette Bissonnette, secretary, spinster, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To act as a real estate, improvement and investment company, under the name of \"Continental Housing Corporation\", The capital stock of the company is divided into 8,000 shares having no nominal nor par value and the amount of the capital stock with which the company will commence its operations will be forty thousand dollars (S40,000).The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General. 1526 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 juin 1950, Tome 82, N° 22 Cowansville Building Supplies, I,td.Avis est donné qu'en vertu ,de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente mars 1050.constituant en corporation: Wilnier Douglas Smith, Sidney Douglas Smith, marchands et Edna Jean Craigie, commis, fille majeure, tous de la ville de Cowansville, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Faire le commerce de matériaux de construction d'aucune et toute sorte, sous le nom de \"Cowansville Building Supplies, Ltd.\", avec un capital de 8100,000 divisé en 1,000 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la ville de Cowansville.district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le trente mars 1950.L'Assistanl-procureur général, 27618 L.DÉSILETS, Drive Yourself Ste- Foy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province tie Québec des lettres patentes, en date du treize avril 1950, constituant en corporation: Joseph-Aimé Dagnault, comptable, Lauriette Chabot, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de Joseph-Aimé Dagnault et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Fernand Dagnault, cultivateur, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de location d'automobiles communément appelé \"Drive Yourself\", ainsi que le commerce de garagiste, sous le nom de \"Drive Yourself Ste-Foy Inc.\", avec un capital de 820,000 divisé en 2,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3,000 chemin Ste-Foy, Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27018-o L.DÉSILETS.Cowansville Building Supplies, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, l>earing date the thirtieth day of March, 1950, incorporating: Wilmer Douglas Smith, Sidney Douglas Smith, merchants, and Edna Jean Craigie, clerk, spinster, all of the Town of Cowansville, in the Judicial District of Bedford, for the following purposes: To trade in building materials of any and every kind, under the name of \"Cowansville Building Supplies, Ltd.\", with a capital stock of S100.000.divided into 1,000 shares of 8100.each.The head office of the Company will be at the Town of Cowansville, in the Judicial District of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of March, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General.Drive Yourself Stc- Foy Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of April, 1950, incorporating: Joseph Aimé Dagnault, accountant, Lauriette Chabot, housewife, wife separate as to property by marriage contract of Joseph Aimé Dagnault and didy authorized by him for the pur|>oses hereof, and Fernand Dagnault, farmer, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of renting automobiles commonly known as \"Drive Yourself\", and also the business of garage keeper, under the name of \"Drive Yourself Ste-Foy Inc.\", with a Capital stock of 820,000 divided into 2,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at 3000 Ste-Foy Road, Ste-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Duskcs Hardware, Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze avril 1950, constituant en corporation: Harry Duskcs, marchand, Shirley Classer, épouse séparée de biens de Harry Duskes, Louis Glazer, avocat, tous de la cité d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de quincaillerie, sous le nom de \"Duskes Hardware, Incorporated\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618 L.DÉSILETS.Duskes Hardware, Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1950, incorporating: Harry Duskes, merchant, Shirley Glasser, wife separate as to property of Harry Duskes, Ixmis Glazer, advocate, all of the City of Outremont, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware, under the name of \"Duskes Hardware, Incorporated\", with a capital stock of 840,000 divided into 400 shares of 8100.each.The head office of the Company will be at Ville St.Laurent, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1527 Gumbo Café Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ('\u2022lé accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.lt.Q.1941, des lettres patentes en date du quatorze avril 1950, constituant en corporation: Dame Clémence Perron Warnicker, veuve non-rcmariée de feu Frank Warnicker, secrétaire, Albert Lunghi et René Bigué, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un restaurant et café, sous le nom de \"Gumbo Café Limited\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618 L.DÉSILETS.Gumbo Café Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of April, 1950, incorporating: Dame Clémence Perron Warnicker, unremarried widow of the late Frank Warnicker \u2014 secretary, Albert Lunghi and René Bigué, clerks, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate a restaurant and cafe, under the name of \"Gumbo Café Limited\", with a capital stock of 820,000.divided into 200 shares of 8100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27018-o Deputy Attorney General.Jerry Motor Sales Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1950, constituant en corporation: Jerry Veillctte, agent de transport, Joseph-Arthur Brassard, géraift, Maurice Veillctte.camionneur, Désiré Chabot, huissier, et André Willette, camionneur, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de véhicules et machines, sous le nom de \"Jerry Motor Sales Limited\", avec un capital de 850,000 divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1950.L'Assistant-procureur général.27018-o L.DÉSILETS.Koolmastcr Company of Canada Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze avril 1950, constituant en corporation: Raymond-D.Boivin.David H.Minshall et Pat Rible, marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et\" faire le commerce de quincaillerie, machinerie et articles en fer, acier, inétal, bois ou autres matériaux, sous le nom de \"Koolmaster Company of Canada Limited\".Le capital de la compagnie est divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et la compagnie commencera ses opération avec 8500.t Le siège social de la compagnie sera à Lachute, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le douze avril 1950.L'Assistant-procu rei i r général, 27618 L.DÉSILETS.La Librairie Variétés Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Jerry Motor Sales Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April, 1950, incorporating: Jerry Veillctte, transport agent, Joseph- Arthur Brassard, manager, Maurice Veillctte, truckman, Désiré Chabot, bailiff, and André Veillctte, truckman, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To manufacture and deal in vehicles and machines, under the name of \"Jerry Motor Sales Limited\", with a capital stock of 850,000 divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Koolmastcr Company of Canada Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of April, 1950, incorporating: Raymond-D.Boivin, David H.Minshall and Pat Rible, merchants, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware, machinery and articles of iron, steel, metal, wood or other materials, under the name of \"Koolmaster Company of Canada Limited\".The capital stock of the company is divided into 100 shares having no nominal or par value and the companv will start its operations with 8500.The head office of the Company will be at Lachute, in the Judicial District of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General.La Librairie Variétés Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have 1528 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S juin 1950, Tome 82, N° 22 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1950, constituant en corporation: André Dussault, Henri-Paul Péladcau, éditeurs, de la cité d'Outremont, et Marie-Marthe Dupont, sténographe, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de librairie, sous le nom de \"La Librairie Variétés Limitée\", avec un capital de $-19,900 divisé en 499 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27G18-0 L.DÉSILETS.La Manécanteric des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Québec, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1950, constituant en corporation sans capital-actions: M.l'abbé Joseph de Smet, prêtre, maître de Chapelle à la Cathédrale de Québec, Louis Fortin et Jean-Paul Parent, avocats, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Procurer à ses membres des avantages matériels, moraux et intellectuels et développer chez eux le goût de la bonne et belle musique, sous le nom de \"La Manécanteric des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Québec, Inc.\" Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-avril 1950.L'Assistant-procureur général.27618-q L.DÉSILETS.Laurcntian Food Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur-de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente mars 1950, constituant en corporation: Henri Crépcau, avocat et conseil en loi du Roi, J.-Wilfrid Lucas, marchand et Françoise Ga-gnon, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de produits alimentaires, sous le nom de \"Laurcntian Food Products Ltd.\", avec un capital de Sl.000,000 divisé en 100,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune et en 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 360 ouest, rue Craig, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente mars 1950.L'Assistant-proeureur général, 27618 L.DÉSILETS.Le Cercle Sportif Longueuil Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouver- been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: André Dussault, Henri Paul Péladeau, editors, of the city of Outremont, and Marie-Marthe Dupont, stenographer, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montréal, for the following purposes: To carry on business as stationers, under the name of \"La Librairie Variétés Limitée\", with a capital stock of $49,900, divided into 499 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.La Manccantcric des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Québec, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: the Rev.abbé Joseph dc Smct, priest, Choir Master of the Cathedral of Quebec, Louis Fortin and Jean Paul Parent, advocates, all of the city and judicial-district of Quebec, for the following purposes: To provide its members with material, moral and intellectual advantages and develop, amongst them, the taste for good and choice music, under the name of \"La Manécanteric des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Québec, Inc.\" The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Laurcntian Food Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of March, 1950, incorporating: Henri Crépcau, advocate and King's Counsel, J.-Wilfrid Lucas, merchant, and Françoise Gagnon.secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in food products, under the name of \"Laurcntian Food Products Ltd.\", with a capital stock of $1,000,000, divided into 100,000 common shares of a par value of $5.each and 5,000 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at 360 Craig St., West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of March, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General.Le Cercle Sportif Longueuil Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1529 neur de la province dc Quebec des lettres paten-tes.en date du cinq avril 1950.constituant en corporation sans capital-actions: Louis Lcspé-rance, employé civil.Cyprien Sainte-Marie, épicier-boucher, et Leopold Potvin, contracteur-électricien, tous de Longueuil, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Organiser et maintenir en existence des terrains dc jeux pour enfants, sous le nom de \"Le Cercle Sportif Longueuil Inc.\" Les.pouvoirs accordés ne permettent pas les jeux à l'argent, les jeux de hasard, les jeux mixtes de hasard et d'habileté, les paris illégaux, et n'autorisent pas non plus la corporation à demander, obtenir ou exploiter un permis octroyé par la Commission des Liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers (pie la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social dc la corporation sera à Longueuil, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général le cinq avril 1950.L'Assistant-procureur général.27018-o L.DÉSILETS.Province of Quebec, bearing date the fifth day of April, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Louis Lespérance, civil servant, Cyprien Ste-Marie, grocer-butcher, and Leopold Potvin, electrical contractor, all of Longueuil, judicial district of Montreal, for the following purposes: To organize and maintain in existence playgrounds for children, under the name of \"\\jç Cercle Sportif Longueuil Inc.\" The powers conferred to not permit gambling, games of chance, games of chance and skill mixed, illegal betting, nor do they authorize the corporation to apply for, obtain or operate a licence granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attornev General, this fifth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 271GS Deputy Attorney General.Le Chauffage Moderne Limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1950, constituant en corporation: P.-Ernest Beauchemin, avocat, Marguerite Bcauchemin et Gaétane Tremblay, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en électricité, chauffage et plomberie, sous le nom de \"Le Chauffage Moderne Limitée\", avec un capital fie 840,000, divisé en 4,000 actions dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Pélicien, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27GIS-0 L.DÉSILETS.Le Chauffage Moderne Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: P.Ernest Bcauchemin, advocate, Marguerite Beauchemin and Gaétane Tremblay, secretaries, all of the city and judicial district of Roberval, for the following purposes: To carry on business as contractors, for electricity, heating and plumbing, under the name of \"Le Chauffage Moderne Limitée\", with a capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of S10 each.The head office of the company will be at St-Félicien, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Les Biscuits du Lac, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1950, constituant en corporation: Dame Amelia.Gagné, rentière, veuve de feu Ephrcm Tremblay.Hector Tremblay, commerçant, et Dame Gra-ziella Côté, épouse contractucllemcnt séparée de biens dudit Hector Tremblay, tous de Ste-Croix, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants : Exercer l'industrie et le commerce de la pâtisserie, sous le nom de \"Les Biscuits du Lac, Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 500 actions ordinaires dc 850, chacune et en 300 actions privilégiées de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Croix, district judiciaire dc Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.Les Biscuits du Lac, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1950, incorporating: Dame Amelia Gagné annuitant, widow of the late Ephrem Tremblay, Hector Tremblay, trader, and Dame (ïraziella Côté, wife separate as to property by marriage contract, of said Hector Tremblay, all of Stc-Croix, judicial district of Roberval, for the following purposes : To ca/ry on the trade and business of pastrycooks, under the name of \"Les Biscuits du Lac, Inc.\", with a capital stock of 840,000.divided into 500 common shares of 850 each, and 300 preferred shares of 850 each.The head office of the company will be at Stc-Croix, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General,, this twenty-fourth dav of March, 1950.L.DÉSILETS.27618 Deputy Attorney General. 1530 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1950, Tome 82, N° 22 L'Oeuvre des Terrains dc Jeux dc Mackayville Incorporée Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Georges Prévost, finisseur de ciment, Alphonse Larivièrc, mécanicien, et Henri Schinck, maçon, tous de Mackayville, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir et encourager le sport, sous le nom de \"L'Oeuvre des Terrains dc Jeux de Mackayville Incorporée\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers (pie la corporation peut posséder est dc 850,000.Le siège social dc la corporation sera à Mackayville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente et un mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Mackayville Incorporée Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Georges Prévost, cement finisher, Alphonse Larivière, mechanic, and Henri Schinck, mason, all of Mackayville, judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote and encourage sport, under the name of \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Mackayville Incorporée\".The amount to which the annual revenue of the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is 850,000.The head office of the corporation will be at Mackayville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1950.L.DÉSILETS.27618 Deputy Attorney General.Mont-Royal Radio Taxi Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix-neuf avril 1950, constituant en corporation : Jean-Jacques Lcfaivre, chauffeur de taxi, Jacques Beauchamp et Jean-Paul Massicotte, avocats, tous des cité et district judiciaire dc Mont-tréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'auto-taxi, camion omnibus, ligne d'autobus, sous le nom de \"Mont-Royal Radio Taxi Limited\", avec un capital de 825,000 divisé en 1,000 actions de 825 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Mont-tréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.Mont-Royal Radio Taxi Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of April, 1950, incorporating: Jean-Jacques Lcfaivre, taxi-driver, Jacques Bcaucliamp and Jean-Paid Massicotte, advocates\", all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the following businesses: auto-taxi, trucks, omnibus, autobus lines, under the name of \"Mont-Royal Radio Taxi Limited\", with a capital stock of 825,000, divided into 1,000 shares of 825 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of April, 1950.L.DÉSILETS.27618 Deputy Attorney General.Processed Wood Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-trois mars 1950, constituant en corporation: Claire Taylor, Mariette St-Arnaud et Betty Pomerantz, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et autrement faire le négoce ou le commerce de bois et plastiques, sous le nom de \"Processed Wood Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées de 8100 chacune et en 200 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Richelieu, district judiciaire de St-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mars 1950.L'Assistant-procureur général, 27618 L.DÉSILETS.Processed Wood Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of March, 1950, incorporating: Claire Taylor, Mariette St.Arnaud and Betty Pomerantz, secretaries, spinsters, all of the city and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and otherwise deal in or with wood and plastics, under the name of \"Processed Wood Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 200 preferred shares of $100.each, and 200 common shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Richelieu, Judicial District of St.Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third dav of March, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1531 Red Birds Ski Club Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur dc la province de Québec, des lettres patentes en date du treize avril 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Alexander Gordon Yeoman, William Patrick Crcagh, commis en loi et Cecil Bruce Cooke, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter et administrer un club de ski, dc sports d'hiver et d'athlétisme, sous le nom de \"Red Birds Ski Club\".Pourvu qu'aucun des pouvoirs accordés au club n'autorise les jeux d'argent, les jeux de hasard et les jeux mixtes de hasard et d'habileté ni la vente d'aucune liqueur alcoolique.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la compagnie peut posséder est dc §100,000.Le siège social du club est situé au village de St-Sauveur-des-Monts, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le treize avril 1950.L'Assist an t -procureur gén éral, 27618 L.DÉSILETS.Regent Apartments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit mars 1950, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, avocats et Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placement, sous le nom dc \"Regent Apartments Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1950.L'Assistant-procureur général.27618 L.DÉSILETS.Red Birds Ski Club Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of April, 1950, incorporating without share capital: Alexander Gordon Yeoman, William Patrick Crcagh, law clerks, and Cecil Bruce Cooke, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate and manage a ski and winter sports and athletic club, under the name of \"Red Birks Ski Club.\" Provided that none of the powers granted to the Club shall authorize games of money, games of chance and games of mixed chance and skill, nor the sale of any alcoholic liquor.The amount of immoveable property which the Club may hold is limited to 8100,000.The head office of the club is in the Village of St-Sauveur-des-Monts, Judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 2701S-o Deputy Attorney General.Regent Apartments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1950, incorporating: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, advocates, and Freda Pomerance, secretary, spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Regent Apartments Inc.\".with a capital stock of 840,000.divided into 50 common shares of the par value of $100.each, and 350 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1950.* L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney Gcncial.Robinson Petroleum Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du treize avril 1950, constituant en corporation: Jacques Béique, avocat, de ville LaSalIc, Gaétan Chabot, avocat, de ville St-Pierre, et Jacqueline Lapierre, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce du pétrole et de gaz naturel ou artificiel, sous le nom de \"Robinson Petroleum Products Inc.\", avec un capital de S40.000 divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.I/?siège social de la compagnie sera à West-mount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize avril 1950.L'Assistant-procu rcu r général.27618-o L.DÉSILETS.Robinson Petroleum Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of April, 1950, incorporating: Jacques Béique, advocate of the town of LaSalle, Gaétan Chabot, advocate, of the town of St-Pierre, and Jacqueline Lapierre, secretary, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in petroleum and natural or artificial gas, under the name of \"Robinson Petroleum Products Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Westmount, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of April.1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General. 1532 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S juin 1950, Tome 82, N° 22 Royal Flooring Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1950 constituant en corporation : Douât Lacoursière, Gérard Lacour-sière et Benoit Lacoursière, tous trois mécaniciens, du village de Princevillc, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux et généralement faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Royal Flooring Company Limited\", avec un capital de §40,000 divisé en 800 actions dc $50 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Prince-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.Service Automatique Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1950, constituant en corporation: Robert Gagnon, Maurice Gagnon, commerçant, et Léon-Georges Gagnon, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises pouvant faire l'objet d'un commerce de restaurateur; d'appareils pouvant servir à la distribution des marchandises précitées et d'appareils récréatifs, sauf les appareils dc jeu au sens de la loi concernant les appareils dc jeu, sous le nom dc \"Service Automatique Ltée\", avec un capital de $20.000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.Standard Welding Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province dc Québec, des lettres patentes en date du douze avril 1950, constituant en corporation: Howard Salter Ross, conseil en loi du Roi, John Cerini, conseil en loi du Roi, Mildred Jones, fille majeure, David Gilbert et Egbert Earl Cockerton, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce d'outillages et accessoires de soudure dc toutes sortes, sous le nom-de \"Standard Welding Supplies Ltd.\", avec un capital de S50.000 divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze avril 1950., L'Assistant-procureur général.27618 L.DÉSILETS.St.George Auto Ltd.Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec-, il a Royal Flooring Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day cf April, 1950, incorporating: Douât Lacoursière, Gérard Lacoursière and Benoit Lacoursière, all three mechanics, of the village of Princcville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To act as general contractors and deal generally in building materials, under the name of \"Royal Flooring Company Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 800 shares of $50 each.The head office of the company will be at Princevillc, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Service Automatique Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: Robert Gagnon, Maurice Gagnon, merchants, and Léon Georges Gagnon, chartered accountant, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in merchandise connected with the restaurant business; devices suitable for the distribution of the aforesaid merchandise and amusement machines, with the exception of gaming machines in the sense of the law concerning gambling devices, under the name of \"Service Automatique Ltée\", with a capital stock of $20,000 divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Standard Welding Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day cf April, 1950, incorporating: Howard Salter Ross, King's Counsel, John Cerini, King's Counsel, Mildred Jones, spinster, David Gilbert and Egbert Earl Cockcrton, advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in welding equipment and supplies of all kinds, under the name of \"Standard Welding Supplies Ltd.\", with a capital stock of $50,000.divided into 5,000 shares of a par value of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General.St.George Auto Ltd.Notice js hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1533 été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1950, constituant en corporation: Jacques Godbout, comptable, J.-Wilfrid Toulouse, vendeur, et Gérard Lessard, mécanicien, tous dc Ville Saint-Georges, district judiciaire dc Beauce, pour les objets suivants: Faire le commerce en général dc véhicules-moteurs et exploiter des garages, sous le nom de St.George Auto Ltd.\", avec un capital dc $30,000 divisé en 300 actions dc $100 chacune.^ Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Georges, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du procureur général le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.Théâtre Riviera, Limitée Riviera Theatre, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1950, constituant en corporation: Paul Gcndron, gérant de théâtre, Marc-P.dc Courval, comptable, et Uldcric-S.Allaire, pro-priétaiie de théâtre, tous dc Vietoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exploiter le commerce et l'entreprise de théâtre et lieux d'amusement, sous le nom de \"Théâtre Riviera, Limitée\" \u2014 \"Riviera Theatre.Limited\", avec un capital de §80,000.divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune cl 000 actions privilégiées de $100 chacune.I,e siège social de la compagnie sera à Drum-mondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général.27618-0 L.DÉSILETS.The Matamajaw Salmon Club, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit avril 1950, constituant en corporation: James Laing Galloway Brown, assistant-secrétaire, de la cité dc Montréal-Ouest, Philip Arthur Sargent, administrateur, rie Hampstead et Edward Donald James Cameron, commis, dc Ville St-Pierre, tous du district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Favoriser la santé et fournir une détente salutaire aux actionnaires, à leurs amis et invités en pratiquant le sport de la pêche et «le la chasse, sous le nom de \"The Matamajaw Salmon Club, Inc.\", avec un capital dc $40,000 divisé en 40 actions de $1,000 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit avril 1950.L'Assistant-procureur général, 2701S L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: Jacques God-bout, accountant, J.Wilfrid Toulouse, salesman, and Gérard Lessard, mechanic, all of the Town of Saint-Georges, judicial district of Beauce, for the following purposes: To deal in motor vehicles and operate garages, under the name of \"St-George Auto Ltd.\", with a capital stock of §30,000 divided into 300 shares of §100 each.The head office of the company will be in the Town of St-Georges, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 276IS Deputy Attorney General.Théâtre Riviera, Limitée Riviera Theatre, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quelle Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April.1950, incorporating: Paul Gendron, theatre manager.Marc P.dc Courval, accountant, and Uldéric S.Allaire, theatre owner, all of Vietoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on and engage in the theatre business, and places of amusement, under the name of \"Theatre Riviera, Limitée\"\u2014\"Riviera Theatre, Limited\", with a capital stock of $80,000, divided into 200 common shares of $100 each, and 000 preferred shares of §100 each.The head oflice of the company will be at Drmnmondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.The Matamajaw Salmon Club, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letter patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of April, 1950, incorporating: James Laing Galloway Brown, assistant secretary, of the City of Montreal West, Philip Arthur Sargent, Executive, of Hampstead, and Edward Donald James Cameron, clerk, of Ville St.Pierre, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To promote the health of and furnish recreation to its shareholders, their friends and guests by the pursuits of fishing and hunting, under the name of \"The Matamajaw Salmon Club, Inc.\", with a capital stock of §40,000.divided into 40 shares of §1,000 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 2701S-o Deputy Attorney General.The Orsmtown Medical Centre Properties Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, des lettres patentes en The Orsmtown Medical Centre Properties Association Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bear- 1531 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S juin 1950, Tome 82, N° 22 date du onze avril 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Murray Raymond Stalker.(îerald Lawrence Sutton, Charles Frederick Hyndman et John Alexander Davidson, tous médecins, du village d'Ormstown, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir une clinique dans le but de donner aux malades et affligés une meilleure aide et assistance, sous le nom de \"The Ormstown Medical Centre Properties Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $300.000.Le siège social dc la corporation sera au village d'Ormstown, comté dc ChAgcauguay, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1950.L'Assistant-procureur général.27618 L.DÉSILETS.Thomas R.Fisher Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre avril 1950, constituant en corporation: Donald Newton Byers, avocat, Errol Klock McDougall et Walter Austin Johnson, avocats, tous des cité et district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et faire le commerce d'obligations, debentures, titres, actions et autres valeurs, sous le nom dc \"Thomas R.Fisher Limited\", avec un capital dc $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général.27618 L.DÉSILETS.Vatel Sous-Vêtements Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province'de Québec des lettres patentes, en date du quatorze avril 1950, constituant en corporation: J.-Adrien Montreuil, manufacturier, Dame J.-Adrien Montreuil, ménagère, et Thérèse Lajoie, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de lingerie, sous le nom de \"Vatel Sous-Vêtements Ltée\", avec un capital de $49,500 divisé en 350 actions ordinaires de $100 chacune et 290 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du procureur général, le quatorze avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27618-0 L.DÉSILETS.ing date the eleventh day of April, 1950, incorporating without share capital: Murray Raymond Stalker, Gerald Lawrence Sutton, Charles Frederick Hyndman and John Alexander Davidson, all physicians, of the Village of Ormstown, Judicial district of Montreal, for the following purposes: To provide a clinic for the purpose of giving better aid and assistance to the sick and afflicted, under the name of \"The Ormstown Medical Centre Properties Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is limited to $300,000.The head office of the Corporation will be at the village of Ormstown, County of Chateau -guay.Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27018-o Deputy Attorney General.Thomas R.Fisher Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: Donald Newton Bycrs, advocate, Errol Klock' McDougall and Walter Austin Johnson, advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate company and deal in bonds, debentures, stocks, shares and other securities, under the name of \"Thomas R.Fisher Limited\", with a capital stock of $40,000.divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618-0 Deputy Attorney General.Vatel Sous-Vêtements Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutcnant-gouvcrnor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1950, incorporating: J.Adrien Montreuil, manufacturer.Dame J.-Adrien Montreuil, housewife, and Thérèse Lajoie, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in lingerie, under the name of \"Vatel Sous-Vêtements Ltée\", with a capital stock of $49,500 divided into 350 common shares of $100 each and 290 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27618 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Cercueils Vietoriaville Limitée Vietoriaville Caskets Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Supplementary Letters Patent Cercueils Vietoriaville Limitée Vietoriaville Caskets Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.fsupplementary QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1535 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 10 mai 1950, changeant le nom de la compagnie \"Victoria Industries Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 décembre 1945, en celui de \"Cercueils Vietoriaville Limitée\"\u2014Victoria-ville Caskets Limited\".Daté du bureau du Procureur général le 10 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27019-o L.DÉSILETS.City Realties & Mortgages Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province tie Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 10 mai 1950, à la compagnie \"The St-Mauricc Valley Agencies Limited\"\u2014 \"Les Agences dc la Vallée du St-Maurice Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 16 janvier 1948, ratifiant son Règlement No 1 : a) changeant son nom en celui de \"City Realties & Mortgages Ltd.\"; b) modifiant et étendant les pouvoirs de ladite compagnie; c) changeant l'endroit du siège social de 58, 5ième rue, Shawinigan-Ealls, district judiciaire des Trois-Rivièrcs, à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27619-o L.DÉSILETS.letters patent bearing date the tenth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Victoria Industries Limited\" incorporated by letters patent dated December 20, 1945, to that of \"Cercueils Vietoriaville Limitée\"\u2014\"Vietoriaville Caskets Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General.City Realties & Mortgages Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the sixteenth day of may.1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The St Maurice Valley Agencies Limited\" \u2014\"Les Agences de la Vallée du St Maurice Limitée\", incorporated by letters patent bearing date the sixteenth day of January, 1948, ratifying it By-law No.1 : a) changing its name into that of \"City Realties & Mortgages Ltd.\"; b) amending and extending the powers of the said company; c) changing the situation of the head office from 58 5th street, Shawinigan Falls, judicial district of Trois-Rivières, to Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General.Dupuis, Parizeau, Tremblay, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 avril 1950, à la compagnie \"Gérard Parizeau et Compagnie, Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 16 août 1949, ratifiant son Règlement Spécial \"A\": 1) changeant son nom en celui de \"Dupuis, Pari/.eau, Tremblay, Limitée\"; 2) réduisant son capital dc 840,000 à 830,000 par l'annulation de 1,000 actions ordinaires de 810 chacune; 3) augmentant son capital-actions de 830,000 à $105,000, par la création de 750 actions privilégiées de $100 chacune, et énumé-rant les privilèges attachés auxdites actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le 20 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27019-o L.DÉSILETS.Edgar Charlnmneau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 5 mai 1950, à la compagnie \"Edgar Charbonneau Limitée\", ratifiant son règlement augmentant son capital-actions de 830,000 à $70,000 par la création de 400 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 5 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27619-0 L.DÉSILETS.Dupuis, Parizeau, Tremblay, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twentieth day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Gérard Parizcau et Compagnie, Ltée\", incorporated by letters patent bearing date the sixteenth day of August, 1949, ratifying its Special By-law \"A\": 1) changing its name into that of \"Dupuis, Parizcau, Tremblay, Limitée\"; 2) reducing its capital from $40,000 to $30,000 by the cancellation of 1000 common shares of $10 each; 3) increasing, its capital stock from 830,000 to $105,000, by, the creation of 750 preferred shares of $100 each, and enumerating the privileges attaching to the said preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General.Edgar Charbonneau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary Letters patent bearing date the fifth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Edgar Charbonneau Limitée\" ratifying its By-law increasing its capital stock from $30,000 to $70,000, by the creation of 400 additional common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General. 1530 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 3 juin 1050, Tome 82, N° 22 Épiciers Uni» Incorporée United Grocers Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du ô mai 1950, à la compagnie \"Épiciers Unis Incorporée\" \u2014 \"United Grocers Incorporated\", ratifiant son Règlement N° 5 réduisant son capital-actions par l'annulation de 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 5 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27019-o L.DÉSILETS.Flintkotc Mines Limited Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 avril 1950, à la compagnie \"Flintkotc Mines Limited\", ratifiant son Règlement N° XVIII réduisant son capital-actions de $1,500,000 à $1,150,000, par l'annulation de 3,500 actions d'une valeur au pair de $100 chacune et le remboursement aux actionnaires d'un montant de S350.000.Daté du bureau du Procureur général, le 19 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27619-0 L.DÉSILETS.Épiciers Unis Incorporée United Grocers Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Queliec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the fifth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Epiciers Unis Incorporée\" \u2014 \"United Grocers Incorporated\", ratifying its By-law No.5, reducing its capital stock by the cancellation of 750 preferred shares of a par value of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy.Attorney General.Flintkotc Mines Limited Notice is hereby given that under part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the nineteenth day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Flintkotc Mines Limited\", ratifying its By-law No.XVIII reducing its capital stock from $1,500.000 to $1,150, 000 by the cancellation of 3,500 shares of a par value of $100 each, and the reimbursement to the shareholders of the sum of $.350,000.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of April, 1950.L.DÉSILETS, 27019 Deputy Attorney General.Fox & Walker Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 25 avril 1950, à la compagnie \"Fox, Walker & Fitch Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 7 octobre 1949, changeant son nom en celui de \"Fox & Walker Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 25 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27019 L.DÉSILETS.Fox & Walker Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of April.1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Fox, Walker & Fitch Ltd.\".incorporated by letters patent dated Octol>cr 7th, 1949, changing its name to that of \"Fox & Walker Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, the 25th of April, 1950.L.DÉSILETS, 27G19-0 Deputy Attorney General.Garage Viau Limitée Viau Garage Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 12 mai 1950, à la compagnie \"J.A.Viau Automobile Limitée\" \u2014 \"J.A.Viau Motors & Sales Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 31 octobre 1947, changeant son nom en celuijde \"Garage Viau Limitée\" \u2014 \"Viau Garage Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 12 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27019-o L.DÉSILETS.H.Smith Transport Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplé- Garagc Viau Limitée Viau Garage Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the twelfth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"J.A.Viau Automobile Limitée\" \u2014 \"J.A.Viau Motors & Sales Limited\", incorporated by letters patent dated October 31, 1947, changing its name to that of \"Garage Viau Limitée\" \u2014 \"Viau Garage Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General.II.Smith Transport Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of May, 1950.were issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL ISAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1537 iiieutaircs en date du 1er mai 1950, à la compagnie \"H.Smith Transport Limited\", ratifiant son règlement N° 22 subdivisant ses 495 actions ordinaires de $100 chacune en 9,900 actions de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 1er mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27019 L.DÉSILETS.J.R.Boisvert & Compagnie Ltée J.R.Boisvert & Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 4 mai 1950, à la compagnie \"J.R.Boisvert & Compagnie Ltée\" \u2014 'M.R.Boisvert & Company Ltd.\", ratifiant un règlement: 1°) réduisant le nombre de ses directeurs de sept à six; 2°) convertissant 380 actions communes du capital-actions actuellement autorisé en 380 actions privilégiées Classe \"A\" de S100 chacune, sujettes aux droits, privilèges et restrictions énumérés dans ledit règlement: 3°) augmentant le capital-actions autorisé de la compagnie de $40,000 à $00,000, par la création de 20 actions privilégiées Classe \"A\" additionnelles et de ISO actions privilégiées Classe \"B\" de S100 chacune, et énumérant les droits, privilèges et restrictions attachés auxdites actions privilégiées; 4°) modifiant les pouvoirs dc la compagnie de la façon prévue dans tel règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 4 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27619-0 L.DÉSILETS.Produits Kent Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ïmï des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 25 avril 1950, à la compagnie \"Produits Kent Limitée\", ratifiant un règlement augmentant son capital-actions de $35,000 à $99,000, par la création de 040 actions additionnelles de $100 acheunc.Daté du bureau du Procureur général, le 25 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27019-o L.DÉSILETS.Québec Meubles, Inc.Quebec Furniture, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 2 mai 1950, à la compagnie \"Quebec Furniture Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 décembre 1947: a) changeant son nom en celui de \"Quebec Meubles, Inc.\" \u2014 \"Quebec Furniture, Inc.\"; b) ratifiant un règlement augmentant son capital-actions de $20,000 à $60,000, par la création de 400 actions ordinaires additionnelles de S100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 2 mai 1950.L'Assistant-procu reu r général, 27619-0 L.DÉSILETS.Province of Quebec, to the company \"H.Smith Transport Limited\", ratifying its By-Law No.22 subdividing its 495 common shares of $100 each into 9,900 shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, the 1st of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619-o Deputy Attorney General.J.R.Boisvert & Compagnie Ltée J.R.Boisvert & Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the fourth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"J.R.Boisvert & Compagnie Ltée\" \u2014 \"J.R.Boisvert & Company Ltd.\", ratifying a by-law: 1) reducing the number of directors from seven to six: 2) converting 380 common shares of the actual authorized capital stock into 380 Class \"A\" preferred shares of $100 each, subject to the rights, privileges and restrictions enumerated in the said by-law; 3) increasing the authorized capital stock of the company from $40,000 to $60,000, by the creation of 20 additional Class \"A\" preferred shares and 180 Class \"B\" preferred shares of $100 each, and enumerating the rights, privileges and restrictions attaching to the said preferred shares; 4) amending the powers of the company in the manner set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General.Produits Kent Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-fifth day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Produits Kent Limitée\", ratifying a bylaw increasing its capital stock from $35,000 to $99,000, by the creation of 640 additional shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General.* Québec Meubles, Inc.Quebec Furniture, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the second day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Quebec Furniture Co.Ltd.\", incorporated by letters patent bearing date the tenth day of December, 1947: a) changing it name into that of \"Quebec Meubles, Inc.\" \u2014 \"Quebec Furniture, Inc.\"; b) ratifying a by-law increasing its capital stock from $20,000 to $60,000 by the creation of 400 additional common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27619 Deputy Attorney General. 1538 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S juin 1950, Tome 82, JV° 22 Salaison Si-Jérôme Ltée Avis est donné qu'on vertu de la première partie de la I>oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 28 avril 1950, à la compagnie \"Abattoir Régional de St-Jérôme Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes eu date du 24 avril 1940, ratifiant: 1° son Règlement N° 17 changeant son nom en celui de \"Salaison St-Jérôme Ltée\"; 2° son Règlement N° 18 augmentant son capital-actions dc $40,000 à $99,000, par la création dc 590 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, et énumé-rant les privilèges attachés auxdites actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général le 28 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27019-o L.DÉSILETS.Salaison St-Jérôme Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-eighth day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Abattoir Régional de St-Jérôme Ltée\", incorporated by letters patent bearing date the twenty-fourth day of April, 1940, ratifying: I.its By-law No.17 changing its name into that of \"Salaison St-Jérôme Ltée\"; 2.its By-law No.IS increasing its capital stock from $40,000 to $99,000, by the creation of 590 additional preferred shares of $100 each, and enumerating tin-privileges attaching to the said preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth day of April, 1950.L.DÉSILETS, 27019 Deputy Attorney General.Walchstraps Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 avril 1950, à la compagnie \"Watchstraps Inc.\", ratifiant son règlement N° 24 augmentant son capital-actions dc $49,900 à $89,900 par la création dc 400 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, et énumé-rant les privilèges attachés auxdites actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le 24 avril 1950.L'Assistant-procureur général, 27619 L.DÉSILETS.Watchstraps Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of April, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Watch-straps Inc.\", ratifying its By-Law No.24 increasing its capital stock from S49.900 to $89,900, by the creation of 400 additional preferred shares of $100 each, and enumerating the privileges attaching to the said preferred shares.Dated at the office of the Attorney General the 24th of April, 1950.L.DÉSILETS, 27019-o Deputy Attorney General.Avis divers Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif dc la Salle Paroissiale dc Bcrthier\", en date du 19 mai 1950, dont le siège social est situé à Berthier-ville, comté de Berthier, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 25 mai 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27621-0 JEAN BRUCHÊSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Village Modèle de St-Timothée, Cté Beauharnois\", en date du 26 avril 1950, dont le siège social est situé à Saint-Timothée, comté de Beauharnois, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire dc la Province, le 17 mai 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27622-o JEAN BRUCHÉSI.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received tin-third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif de la Salle Paroissiale de Bcrthier\" under date the nineteenth day of May.1950, whereof the head office is at Bcrthicrville.county of Berthier, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-fifth of May, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27621 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received tin-third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Village Modèle de St-Timothée, Cté Beauharnois\", under date the twenty-sixth day of April, 1950.whereof the head office is at Saint-Timothée.county of Beauharnois, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this seventeenth day of May, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27622 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1539 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative d'Habitation des Machinistes de Montréal\", en date du 18 avril 1950, dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 13 mai 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 27632-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif de St-Joseph dc Lévis\", en date du 19 mai 1950, dont le siège social est situé à St-Joseph de Lévis, comté de Lévis, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 24 mai 1950.Le Sous-secrétairc de la Province, 27033-o JEAN BRUCHÉSI.Le Telephone Labelle Limitée Sommaire des règlements spéciaux Les règlements spéciaux passés par les administrateurs de \"Le Téléphone Labelle Limitée\" pourvoient à la distribution des biens de la compagnie au pro rata entre ses actionnaires et, après telle distribution, à la dissolution de la compagnie et à l'abandon de sa charte.Vraie copie certifiée, le 17 mai 1950.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Coopérative d'Habitation des Machinistes de Montréal\" under date the 18th day of April, 1950, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of May, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27G32 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif de St-Joseph de Levis\", under date the nineteenth day of May, 1950, whereof the head office is at St-Joseph de Levis, County of Levis, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-fourth day of May, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 27633 Under Secretary of the Province.Le Téléphone Labelle Limitée Summary of Special By-Laws Special By-laws enacted by the Directors of \"Le Téléphone Labelle Limitée\" provide for the distribution of all assets of this Company pro rata amongst its shareholders and, upon such distribution being made, for the dissolution of the Company and the surrender of its Charter.A certified true summary, May 17th, 1950.27634-0 Le Secrétaire-trésorier, H.-L.LAMBOURNE.27634-0 H.-L.LAMBOURNE.Secretary-Trcasu rer.Action en séparation de biens Action for separation as to property Canada, Province de Québec, District de Terrebonne, cour supérieure, N° 11,160.Dame Fiorina Granger,, demanderesse, vs Dosithée Gareau, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, le 13 avril 1950.Saint-Jérôme, le 12 mai 1950.Le Procureur de la demanderesse, 27620-o LUCIEN THINEL.Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne, Superior Court, No.11,160.Dame Fiorina Granger, plaintiff; vs Dosithée Gareau, defendant.An action for separation as to property was taken at Saint-Jérôme, district of Terrebonne, on April 13, 1950.Saint-Jérôme, May 12, 1950.LUCIEN THINEL, 27620 Attorney for the plaintiff.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 582 Québec, le 24 mai 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-cn-Conseil.Section \"A\" Orders in Council ORDER IN COUNCDL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 582 Quebec, May 24, 1950.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"A\" Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating aux employés de laiterie dans les cités de Que- to the dairy employees in the cities of Quebec 1540 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 3 juin I960, Tome 82, N° 22 bec et Lévis et un rayon de cinq (5) milles de leurs limites.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés «le laiterie dans les cités dc Québec et Lévis, rendue obligatoire par le décret numéro 4SI du 5 mai 1949, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 22 avril 1950; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 481, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"f de l'article I est remplacé par le suivant: \"t\") Jour» fériés: Les mots \"jours fériés\" désignent les jours suivants: la fête de la Saint-Jean-Baptistc, la fête du Travail, le lendemain du jour de Noël et le lendemain du Premier de l'An.\" 2° L'article III est remplacé par le suivant: \"III.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend les cités dc Québec et Lévis et les municipalités situées ou comprises, en tout ou en partie dans un rayon de dix (10) milles des limites desdites Cités dc Québec et Lévis.3° L'article IV est remplacé par le suivant: \"IV.Salaires minima: Tout salarié, quel que soit le mode de rémunération, ne doit pas recevoir un salaire inférieur à celui mentionné ci-après: par semaine Contremaître.$41.80 Essayeur et contremaître.41.80 Essayeur non contremaître.34.10.Préposé à la fabrication.33.00 Hommes dc service: Catégorie \"A\".34.00 Catégorie\"»\".30.00 Catégorie \"C\".20.00 Expéditeur.34.10 Vendeur sur la livraison du lait, travaillant régulièrement, que la durée hebdomadaire dc son travail soit dc 02 heures ou moins, $20.00 par semaine de salaire de base, plus 3% de commission sur toute vente à l'exception du beurre et de la crème.La commission sur le beurre doit être dc $0.02 la livre sur toute vente faite au prix du détail, et 14 cent la livre sur toute vente au prix de gros.La commission sur la crème doit être dc $0.02)4 sur chaque chopine de crème vendue au prix du détail et de $0.0134 1* chopine sur la crème vendue au gros.Tout vendeur dont le salaire et la commission sont inférieurs à vingt-cinq dollars par semaine ($25.00) doit recevoir un salaire garanti pour ce montant.par semaine Vendeur de crème glacée.$30.80 Livreur.32.00 Aide.19.80 l'heure Employé occasionnel.0.7134 Il ne doit être fait aucune diminution sur le salaire d'un salarié pour les jours de fête religieuse d'obligation, les jours fériés non ouvrables et les jours de congé.and I,evis and a radius of five (5) miles from their limites.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 103 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the dairy employees in the cities of Quebec and Levis, rendered obligatory by the decree numl>er 481 of May 5, 1949, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 22.1950; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 481, be amended as follows: 1.Subsection \"i\" of section I is replaced by the following: \"1) Holidays: The word \"holidays\" means the following days: St Jean Baptiste Day, Labour Day, the day after Christmas and the day after New Year's.\" 2.Section III is replaced by the following: \"HI.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree comprises the cities of Quebec and Levis and the municipalities situated or included, in whole or part, in a radius of ten (10) miles from the limits of the said cities of Quebec and Levis.\" 3.Section IV is replaced by the following: \"IV.Minimum wages: Every employee, on any remuneration basis, shall not receive less than the following rates: per week Foreman.$41.80 Tester-foreman.41.80 Tester only (not foreman).34.10 Production worker'.33.00 Service man : Category \"A\".34.00 Category \"B\".30.00 Category \"C\".20.00 Shipper.34.10 Salesman on milk delivery, working regularly, whether the weekly duration of labour be one of 02 hours or less, $20.00 per week as basic wages plus 3% commission on any sale excepting butter and cream.The commission on butter shall be $0.02 per pound on any sale at retail price, and 34 cent per pound on any sale at wholesale price.The commission on cream shall be $0.0234 for each pint of cream sold at retail price, and $0.0134 per pint sold at wholesale price.Any salesman whose wages and commission do not attain twenty-five dollars per week ($25.00) shall nevertheless receive that amount.per week Ice cream salesman.$30.80 Delivery man.32.00 Helper.19.80 per hour Occasional employee.$0.7134 No deduction may be made on the wages of an employee because of religious and other holidays or days off. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1541 Quand, dans une semaine donnée, le nombre d'heures de travail requis d'un salarié, autre que l'employé occasionnel, est inférieur à la semaine normale, il ne doit être fait aucune déduction du salaire prévu au présent article, à moins que la diminution des heures ne soit occasionnée par des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur.\" 4° A l'article V, l'avant-dernier paragraphe est remplacé-par le suivant: \"Dans les municipalités de la Rive Sud du Saint-Laurent, la livraison du lait est permise les dimanches et fêtes religieuses du 15 mai au 15 septembre.\" 5° fx* troisième paragraphe de l'article VI est abrogé.(J° A Particle XVI, le paragraphe suivant est ajouté: \"Si un salarié quitte son emploi ou est congédié après six mois de service, il doit recevoir une indemnité en argent équivalente à trois jours de salaire.\" 7° L'article XX actuel intitulé \"Durée du décret\" devient l'article XXII et les deux nouveaux articles suivants sont ajoutés au décret: \"XX.Accessoires: L'employeur doit fournir au salarié les accessoires servant à l'exécution de son travail, tels que paniers, sacs à argent, etc., mais ledit salarié en reste personnellement responsable.\" \"XXI.Avis dc huit jours: Avant de congédier un salarié ayant un an et plus de service, tout employeur doit lui donner un avis de huit (8) jours, à moins de renvoi pour cause jugé par le ( omité paritaire.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 27(544-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 582 Québec, le 24 mai 1950.Présent : Le Lieutcnant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"B\" Concernant une modification du décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les villes de Vietoriaville et Arthabaska et le village de Warwick.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes a la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les villes de Vietoriaville et Arthabaska et le village de Warwick, rendue obligatoire par le décret numéro 98 du 29 janvier 1948, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 22 avril 1950; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 98, soit modifié comme suit: When, in the course of a week, the number of hours of work required from an employee, other than an occasional employee, is less than that of the standard work week, there shall be no deduction on the wages established in the present section unless the reduction in working hours be caused by circumstances beyond the employer's control.\" 4.The second last paragraph of section V is replaced by the following: \"In municipalities on the South shore of the St.Lawrence, milk delivery may be made on Sunday and religious holidays from May 15 to September 15.\" 5.The third paragraph of section VI is deleted.6.The following paragraph is added to section XVI: \"If an employee leaves or is dismissed after six months of service, he shall receive a cash indemnity equivalent to three days' wages.\" 7.The present section XX headed \"Duration of the decree\" becomes section XXII and the following two sections are added to the decree: \"XX.Equipment: The employer shall provide the employee with all necessary equipment, such as baskets, money bags, etc.for which, however, the employee shall be personnally responsible.\" \"XXI.Eight days notice: Every employer shall, in case of discharge, give eight days notice to every employee with one year or more of service except when the dismissal is caused by the employee's conduct, the latter cases to be referred to the Parity Committee.\" (Document \"A\" annexed to the Order) A.MORISSET, 27644-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 582 Quebec, May 24, 1950.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"B\" Concerning an amendment of the decree relating to the barber and hairdressing trades in the towns of Vietoriaville and Arthabaska and the village of Warwick.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the towns of Vietoriaville and Arthabaska and the village of Warwick, rendered obligatory by the decree number 98 of January 29, 1948, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree and its amendments; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 22, 1950; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendment; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 98, be amended as follows: 1542 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1960, Tome 82, N° 22 \"Le paragraphe \"a\" de l'article IV est modifii afin dc réduire à SS.00 le prix minimum d'uni \"ondulation permanente à froid\" dans toute h juridiction territoriale du décret.\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté).A.MORISSET, 27044-o Greffier du Conseil Exécutif.Subsection \"a\" of section IV is amended to reduce to S8.00 the minimum price of a permanent wave, cold process, in the entire territorial jurisdiction of the decree.(Document \"B\" annexed to the Order).A.MORISSET, 27644-0 Clerk of the Executive Council.ARRETE EN CONSEIL ORDER IN COUNCIL CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 5S2 Number 582 Québec, le 24 mai 1950.Quebec, May 24, 1950.Présent: Le Leiutenant-Gouvcrncur-en-Conscil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Section \"C\" ' Part \"C\" Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating aux métiers de barbier et coiffeur dans la to the barber and hairdressing trades in the région dc Sherbrooke.district of Sherbrooke.Attendu que conformément aux dispositions Whereas, pursuant to the provisions of the de la Loi de la convention collective (Statuts Collective Agreement Act (Revised Statutes of refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amen- Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the dements), les parties contractantes à la conven- contracting parties to the collective labour agree-tion collective de travail relative aux métiers ment relating to the barber and hairdressing de barbier et coiffeur dans la région dc Slier- trades in the district of Sherbrooke, rendered brooke, rendue obligatoire, par le décret numéro obligatory by the decree number 918 of June 4, 918 du 4 juin 1947, ont présenté au Ministre du 1947, have submitted to the Minister of Labour Travail une requête à l'effet de modifier ledit a request to amend the said decree, and its décret, et ses amendements; amendments; Attendu epic ladite requête a été publiée dans Whereas the said request has been published la Gazette officielle de Québec, édition du 22 avril in the Quebec Official Gazette, issue of April 22, 1950; t 1950; Attendu qu'aucune objection n'a été formu- Whereas no objection has been made against lée contre l'approbation des modifications pro- the approval of the proposed amendments; posées; Il est ordonné, en conséquence, sur la propo- It is ordained, therefore, upon the recora-sition de l'honorable Ministre du Travail: inondation of the Honourable Minister of La- bour, Que ledit décret, numéro 918, soit modifié That the said decree, number 918, be amended comme suit: as follows: 1° Les paragraphes \"h\" et \"i\" suivants sont 1.The following subsections \"h\" and \"i\" ajoutés à l'article I: are added to section I: h) Une coupe de cheveux \"en brosse\" \"h) A brush-cut at the barbers' means the (brush cut) chez les barbiers signifie les cheveux cutting of the hair so that it stands upright on coupés en tenue verticale, droits sur la tête, the head, irrespective of the kind of haircut sans considération du genre de coupe alentour around the head.There is no half brush-cut de la tête.Il n'existe pas de demi-brosses et and the use of cosmetics is indifferent in this l'usage de cosmétiques est indifférent dans cette operation.\" opération.\" \"i) Une coupe de cheveux dite \"Hollywood\" \"i) A \"Hollywood\" haircut means that haircut désigne toute coupe de cheveux très basse en which is very low in the back, very thick around arrière, très épaisse tout le tour de la tête et le the head and partly brush cut on the top.\" dessus de la tête coupé en partie \"en brosse (brush cut)\".2° Le dernier alinéa du paragraphe \"b\" de 2.The last paragraph of subsection \"b\" of l'article II est remplacé par le suivant: section II is replaced by the following: \"Zone G: La ville de Richmond avec un rayon \"Zone G: The town of Richmond with a radius de cinq (5) milles de ses limites.\" of five miles from its limits.\" 3° Les mots \"les mercredi et jeudi-saint\" 3.The words \"on Spy Wednesday and Maun-apparaissant à l'alinéa 1 du paragraphe \"d\" de day Thursday\", mentioned in paragraph 1 of l'article III, sont radiés et remplacé par les mots subsection \"d\" of section III, are deleted and \"le Jeudi-Saint\".replaced by the words: \"onMaunday Thursday.\" 4° L'alinéa 3 du paragraphe \"d\" de l'article - 4.Paragraph 3 of subsection \"d\" of section III est remplacé par le suivant: III is replaced by the following: \"3.Cependant, le lundi, la durée des heures \"3.However, on Monday, the working hours de travail est prolongée jusqu'à 6.30 p.m.dans are extended until 6.30 p.m., in zone I and until la zone I et jusqu'à 6.00 p.m.dans la zone II, 6.00 p.m.in zone II in the weeks preceding les semaines précédant Pâques et Noël.\" Easter and Christmas.\" 5° L'alinéa 7 suivant est ajouté au paragraphe 5.The following paragraph 7 is added to \"d\" de l'article III.: subsection \"d\" of section III: \"7.Dans la zone I, les heures de travail se \"7.In zone I, the working hours end at 9.00 terminent à 9.00 p.m.les jours du Marché p.m.on Landsdowne Market day.\" Landsdowne.\" .6° L'article IV est remplacé par le suivant: 6.Section IV is replaced by the following: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1050, Vol.82, No.22 1543 'TV.Jours de fêtes chômées: Il n'y a pas de travail les dimanches, le Premier de l'An, l'Epiphanie, l'Ascension, la Toussaint, le Jour d'Actions de GrAces (fixé par proclamation), l'Immaculée-Conception, la Noèl et la fête du Travail.11 n'y a pas de travail également la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) et le jour dc la Confédération (1er juillet); cependant si ces deux fêtes tombent un vendredi ou un samedi le congé est remis au hindi suivant.Dc plus, sont également chômés par les coiffeurs et coiffeuses seulement les jours suivants: 2 janvier, lundi de Pâques, 24 mai et 2G décembre.Lorsqu'un des jours chômés ci-haut tombe un dimanche, le congé est remis au lendemain (lundi) pour les barbiers seulement.7° L'item suivant est ajouté à l'échelle des prix minima des services pour les barbiers, apparaissant à l'article VI: \"Traitement à l'huile.80.75 (Zone I seulement)\" 8° A l'article VI, les dispositions relatives aux prix minima pour la coupe des cheveux des enfants, les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées sont biffées et remplacées par les dispositions suivantes: \"Le prix dc la coupe dc cheveux pour enfants est le même que le prix pour adultes: i) Le samedi et la veille des fêtes chômées, dans les zones III, VII, XI et XII.ii) Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées, deux (2) jours avant Noël et deux (2) jours avant le Premier de l'An, dans les zones I, IL IV, V, VI, VIII, IX et X.\" 9° Les mots \"ondulation permanente simple\" apparaissant au début du tableau des prix minima des services pour les coiffeurs et coiffeuses\", article VI, sont remplacés par les suivants \"ondulât ion permanente\".10° Dans le tableau des prix minima pour les services des coiffeurs et coiffeuses, à l'article VI, le prix «l'une ondulation permanente à froid est réduit à $7.00 dans les zones \"A\" et \"B\" et à S8.00 dans la zone \"E\".11° L'alinéa 1 du paragraphe \"2 of 1% ot the wages established for the employee: i.receiving the lowest rate of pay, i.e.88.00 per week, in the areas governed by decree 2331; ii.receiving the average rate of pay.i.e.820.00 per week, in the areas governed by decrees 2801 and 3516.c) The employees shall pay to the Parity Committee, out of their wages, bonuses and percentages, an assessment of Y of 1% if they are governed by decree 2861, and an assessment of M of 1% if governed by decrees 2331 and 3516.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee may supply the professional employers governed by the said decrees with report forms on which shall be inscribed: the name in full and address of every employee in their employ, the employee's competency, the number of regidar and overtime hours worked each week, the nature of such work and the wages paid, as well as the sums to be forwarded to the Parity Committee.The professional employer shall collect from the wages of every one of his employees the sums owed to the Parity Committee and remit same himself to the said Committee.The Parity Committee requires every report of the professional employer to be signed and accompanied by his assessments, as well as the assessments of the artisans or employees as the case may be, and forwarded to its office, 29 1550 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1960, Tome 82, N° 22 Gordon, Sherbrooke, Que clans les dix premiers jours dc chaque mois.Le Comité Paritaire a le droit et le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions dc la Loi de la Convention Collective, le comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail, aux dates suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé un état des recettes et des déboursés du Comité Paritaire du Commerce dc Détail des Cantons de l'Est pour la période comprise entre le 1er juin 1950 et le 1er juin 1951.Comité paritaire du commerce de détail des Cantons de l'Est Etat des recettes et des déboursés probables du 1er juin 1950 au 1er juin 1951.Recettes probables: Décret numéro 2331: (Sherbrooke): Cotisations dc }/i de 1% des employeurs professionnels, et des salariés, et %de 1% des artisans $1,300.00 Divers.50.00 $1,350.00 Décret, numéro 3510 (Windsor): Cotisations dc ]4 de 1% des employeurs professionnels, et des salariés, et ^ dc 1% des artisans 416.00 Décret numéro 2801 (Richmond): Cotisations de %, de 1% des employeurs professionnels, des salariés et (les artisans.500.00 S2.206.00 Déboursés probables: Décret numéro 2331 (Sherbrooke): Salaires et frais d'administration.SI, 144.00 Déplacement.206.00 $1,350.00 Décret numéro 3516 (Windsor): Frais d'administration.390.00 Déplacement et divers.26.00 416.00 Décret numéro 2861 (Richmond) : Frais d'administration.390.00 Déplacement et divers.110.00 500.00 52,266.00 Gordon St., Sherbrooke, within the first ten (10) days of each month.The Parity Committee has the right and power 'to exact sworn reports when it deems it advisable.3.Financial report In pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Eastern Townships Retailers' Joint Committee for the period comprised between June 1, 1950, and June 1, 1951.Eastern Townships Retailers' Joint Committee Estimate of the receipts and expenses from June 1st, 1950, to June 1st 1951.Probable receipts: Decree number 2331 (Sherbrooke) : Assessments of of 1% from professional employers and employees and J/£ of 1% from artisans.$1,300.00 Miscellaneous.50.00 $1,350.00 Decree number 3516 (Windsor): Assessments of % of 1% from professional employers and em- ployees and y% of 1% from artisans.416.00 Decree number 2861 (Richmond) : Assessments of % of 1% from professional employers, artisans and employees.500.00 $2,266.00 Probable expenses: Decree number 2331 (Sherbrooke) : Salaries and administration ex- penses.$1,144.00 Travelling.206.00 $1,350.00 Decree number 3510 (Windsor): Administration expenses.390.00 Travelling and miscellaneous.26.00 $ 416.00 Decree number 2861 (Richmond) : Administration expenses.390.00 Travelling and miscellaneous.110.00 $ 500.00 $2,266.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GERARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 3 juin 1950.27654-0 Quebec, June 3, 1950.27654-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1960, Vol.82, No.22 1551 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire des Arts graphiques du Sague-nay, établi en exécution du décret numéro 1414 du 14 décembre 1949, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 582 du 24 mai 1950 (section \"D\"), le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements) à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après décrits: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juin 1950 au 1er juin 1951; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1414 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y2 de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 1414 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $0.25 par semaine.- c) Les salariés régis par ledit décret numéro 1414 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à H de 1% de leur rémunération (salaire fixe, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that \"Le Comité paritaire des Arts graphiques du Saguenay\", established under decree No.1414 of December 14, 1949, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.582 of May 24, 1950 (part \"D\"), in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments) to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by said decree, according to the method and rate hereafter described: 1.Assessment The period of levy extends from June 1st, 1950 to June 1st, 1951; such levy shall apply as follows: a) Every professional employer governed by the decree number 1414 shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^£ of 1% of their payroll for the employees governed by the said decree.b) All artisans governed by the said decree number 1414 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to % of 1% of the wages established in the decree for the journeyman receiving the lowest pay, i.e.$0.25 per week.c) Every employee governed by the said decree, number 1414, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% of his remuneration (fixed wages, percentages, commissions, allocations or bonuses).2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the said Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete his report, sign and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments imposed on the employees by means of a deduction on the latter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments imposed by the present bylaw are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, five days notice shall be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31. 1552 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin I960, Tome 82, N° 22 Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des Arts Graphiques du Saguenay, pour la période comprise entre le 1er juin 1950 et le 1er juin 1951.Comité paritaire des Arts Graphiques du Saguenay Siège social: Chicoutimi État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er juin 1950 et le 1er juin 1951.Recettes: Cotisations CA de 1%): Employeurs professionnels.$ S75.00 Artisans.50.00 Salariés.875.00 Honoraires d'examen.20.00 §1,820.00 Déboursés: Salaire et déj)cnscs du secrétaire-gérant.81,300.00 Papeterie, timbres, etc.175.00 Frais de représentation et jetons de présence des membres du Comité.200.00 Frais d'inspection.145.00 81,820.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 juin 1950.27054-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes (pie la Commission conjointe des Coiffeurs pour Dames de Montréal, établie en exécution du décret numéro 1343, du 29 mai 1941, et amendements, a été autorisée par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 582 du 24 mai 1950, section \"F\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 7 juin 1950 au 7 juin 1951; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné; a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 1343 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de la liste des salaires fixes, commissions, bonis, allocations qu'ils versent à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans assujettis audit décret numéro 1343, doivent également verser au comité paritaire une somme équivalente à % de 1% du salaire moyen de 825.00 par semaine.c) Les salariés assujettis audit décret, numéro 1343, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leurs salaires fixes, commissions, bonis et allocations.2.Mode dc perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le comité paritaire met à la disposition Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the \"Comité paritaire des Arts graphiques du Saguenay\" for the period between June 1st, 1950 to June 1st, 1951.Comité paritaire des Arts Graphiques du Sague.vay (Corporate scat) : Chicoutimi Estimate of the receipts and disbursements for the period between June 1st, 1950 and June 1st, 1951.Receipts: Assessments (Yi of 1%): Professional employers.$ 875.00 Artisans.50.00 Employees.875.00 Examination fees.20.00 $1,820.00 Disbursements: Salary and expenses of the Secretary-Manager.$1,300.00 Stationery, stamps, etc.175.00 Representation and meeting expenses of Committee members.200.00 Inspection fees.145.00 $1,820.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 3, 1950.27654-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Commission of the I>adies Hairdressing Trade of Montreal, formed under decree number 1343.of May 29, 1941, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 582 of May 24, 1950, part \"F\", pursuant to the provisions of Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to collect levies from professional employers, artisans and employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned : 1.Levy The period of levy extends from the 7th of June 1950 to the 7th of June 1951 and applies as hereinafter mentioned: a) The professional employers governed by the decree No.1343 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y2 of 1% of the fixed wages and commissions, bonuses, allocations paid to their employees subject to the said decree.b) All the artisans subject to decree No.1343 must, also pay to the Parity Committee Y2 of 1% of the wage rate of $25.00 per week.c) The employees governed by the decree 1343 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yl °f 1% °f their fixed wages and commissions, bonuses and allocations.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these levies, the Parity Committee shall furnish the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1553 des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les heures de travail, les salaires payés, y compris la proportion des commissions gagnées, l'argent perçu au cours de la semaine et les sommes versées au comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au comité paritaire à tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même la rémunération de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent au comité paritaire et les faire parvenir lui-même audit comité en même temps que sa propre cotisation.Le rapport de l'employeur professionnel, accompagné des cotisations, doit être signé et transmis au comité paritaire dans les cinq jours (pli suivent l'expiration de la période pour laquelle il est exigible.Le comité paritaire a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à pro]>os.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions dc la Loi dc la convention collective, le comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des dépenses prévues de la Commission conjointe des coiffeurs pour dames de Montréal, pour la période comprise entre le 7 juin 1950 et le 7 juin 1951.Commission conjointe des Coiffeurs four Dames de Montréal Budget proposé pour la période comprise entre le 7 juin 1950 et le 7 juin 1951.Recettes: Cotisations de 1%): Employeurs.$ 5,800.00 Salariés.5,800.00 Artisans.3,600.00 Kxamens et apprentis.700.00 Divers, pénalités, etc.100.00 S 16,000.00 Déboursés: Salaires.$ 5,216.00 Frais d'auto et déplacements.2,520.00 Loyer et téléphone.760.00 Taxes et assurances.120.00 Timbres, frais de poste et accise .300.00 Papeterie et divers pour bureau.450.00 Entretien du bureau.60.00 Vérification.200.00 Frais judiciaires et extrajudiciaires.2,500.00 Frais d'enquêtes.750.00 Frais d'examens.800.00 Frais de déplacements pour assemblées 1,050.00 Mobilier de bureau.300.00 Subvention à la Commission d'apprentissage.500.00 Divers et imprévus.474.00 SI 0,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 juin 1950.27654-0 professional employers with printed forms, indicating the hours of labour, the wages paid, including the proportion of commissions earned* the money collected during the week and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall have these report forms filled in and sent to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of every one of his employees, the sums owed to the Parity Committee, and send same himself to the said committee, together with his own assessments.The report of every professional emplcyer must l>e signed and sent, together with assessments, to the Parity Committee within (5) days after the date of expiration of the period for which it is requirable.The Committee has the right to exact sworn reports every time it deems it advisable.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.An estimate of the probable receipts and disbursements of the Joint Commission of the Ladies Hairdressing Trade of Montreal, for the period comprised between June 7, 1950 and June 7, 1951, is annexed hereto.Joint Commission of the Ladies' Hairdressing Trade of Montreal Proposed Budget for the period between June 7, 1950 and June 7, 1951.Receipts: Assessments CA of 1%): Employers.$ 5,800.00 Employees.5,800.00 Artisans.3,600.00 Examinations and apprentices.700.00 Miscellaneous, penalties, etc.100.00 $16,000.00 Disbursements: Salaries.$ 5,216.00 Automobile and travelling expenses 2,520.00 Rent and telephone.760.00 Taxes and insurance.120.00 Postage and excise duties.300.00 Stationery and miscellaneous office expenses.450.00 Office upkeep.60.00 Audition.200.00 Judicial and extra-judicial fees.2,500.00 Investigation expenses.750.00 Examination expenses.800.00 Travelling expenses re: meetings .1,050.00 Office furniture.300.00 Subvention to the Apprenticeship Commission.500.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.474.00 $16,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 3, 1950.27654-0 15541 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1950, Tome 82, N° 22 Département du trésor Assurances AVIS Avis est par les présentes donne que la Compagnie d'Assurances Mutuelles des Marchands Détaillants, constituée en corporation par la Loi S Geo.VI, chapitre 78, ayant réassuré tous ses contrats d'assurance en vigueur, le 15 février 1950, auprès de \"The Central Manufacturers Mutual Insurance Company\", une corporation dont le siège social est à Van Wert, Etat de Ohio, Etats-Unis d'Amérique, et autorisée à faire affaires dans la Province, en vertu d'un contrat dc réassurance intervenu entre ces deux corporations le 15 février 1950 pour prendre effet le même jour, s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en conseil, le premier jour d'août 1950, pour obtenir la remise des valeurs déposées auprès du Trésorier de la Province, conformément à l'article 94 dc la Loi des assurances.Avis est dc plus donné que tous les créanciers éventuels ou actuels qui s'opposeront à la remise des valeurs à la Compagnie d'Assurances Mutuelles des Marchands Détaillants doivent produire leur opposition au Bureau dc l'Inspecteur des assurances, Service des assurances, Hôtel du Gouvernement, Québec, le 1er jour d'août 1950 ou avant le 1er jour d'août 1950.Donné à Montréal, ce quinzième jour d'avril 1950.La Compagnie d'Assurance Mutuelles des Marchands Détaillants, Le Secrétaire, 2763G-0 FERNAND BOISSEAU.Treasurery Department Insurance NOTICE Notice is hereby given that the Retail Merchants Mutual Insurance Company incorporated by the Act 8 Geo.VI, chapter 78, having reinsured all its outstanding contracts of insurance, the 15th of February 1950, with The Central Manufacturers Mutual Insurance Company, a corporation whose head office is situate at Van Wert, State of Ohio, United States of America, and authorized to do business in the Province, according to a reinsurance contract entered into by these two corporations the 15th of February 1950 to take effect the same day, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, on the 1st of August 1950 for the release of its securities deposited with the Treasurer of the Province in accordance with the Section 94 of the Quebec Insurance Act.Notice is hereby further given that all creditors, contingent or actual, opposing the release of the securities to the Retail Merchants Mutual Insurance Company must h'le their opposition at the office of the Inspector of Insurance, Department of Insurance, Parliament Buildings, Quebec, on or before the 1st day of August 1950.Given at Montreal, this fifteenth day of April 1950.Retail Merchants Mutual Insurance Company, FERNAND BOISSEAU, 27630-o Secretary.Voirie AVIS Les parties de chemins ci-après désignées cesseront a l'avenir d'être entretenues par le ministère dc la Voirie.Ayant été remplacées par de nouvelles sections redressées et améliorées, elles sont devenues inutiles pour la circulation: Route N° 55 \u2014 Tour du Lac Saint-Jean.Dans le comté de Roberval.Dans la municipalité dc la paroisse dc Saint-Prime: Une section de 1078 pieds, au nord-est de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots Nos P-37 et P-3SA.Dans la municipalité de Saint-Félicien: Une section dc 1572 pieds, au nord de la nouvelle route, sur ou vis-à-vis les lots Nos P-39.Québec, le 17 mai 1950.Le Ministre de la Voirie, 27037-o ANTONIO TALBOT.Greffe de notaire Avis est par le présent donné, conformément aux dispositions du Code du Notariat, qu'une requête a été présentée à la Chambre des Notaires par Me Frederick K.Stevenson, notaire demeurant et exerçant à Montréal, district judiciaire de Montréal, par laquelle il demande la transmission en sa faveur des minutes, répertoire et index de Me Randolph Bridgman, notaire de Montréal.Montréal, 29 mai 1950.Le Secrétaire-trésorier de la Chambre des Notaires, 27638-0 ARTHUR COURTOIS.Roads NOTICE The parts of the roads hereinafter mentioned will cease for the future to be maintained by the Department of Roads.Having been replaced by new straightened and improved sections, they have become useless for traffic.Highway No.55 \u2014 Lake St.John Tour.In the county of Roberval.In the municipality of the parish of Saint-Prime: A section of 1678 feet, northeast of the new highway, on or facing lots Nos.P-37 and P-38A.In the municipality of Saint Félicien: A section of 1572 feet, north of the new highway, on or facing lots Nos P-39.Quebec, May 17, 1950.ANTONIO TALBOT, 27637 Minister of Roads.Notarial Record Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Notarial Cede, that a petition has been presented to the Board of Notaries, by Me Frederick K.Stevenson, Notary residing and practising at Montreal, Judicial District of Montreal, whereby he asks for the transfer in his favour of the minutes, repertory and index of Me Randolph Bridgman, Notary of Montreal.Montreal, May 29th 1950.ARTHUR COURTOIS, Secretary-Treasurer of the Board 27638-0 of Notaries. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1555 Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OFILAURENTIDES Candidats pour l'admission X l'etudeJdu droit Candidates for the admission to the study of law Examena de juillet 1950\u2014 Exaininationa of July, 1960 Nome Names\tPrénoms Surnames\tAgo\tRésidence Residence\tCollèges Colleges Blanchard.\t\t20 19\tSte-Thérèso.\tSéminaire de Ste-Thérèse.Collège de L'Assomption.\t\t\tSt-Paul l'Ermite.\t .Juliette, 31 mai 1950 \u2014 Joliette, May 31, 1950.Le Secrétaire du Barreau des Laurentides, MAURICE MAJEAU, 27018-22-2-o Secretary of the Bar of Laurentides.BARREAU DE SAINT-FRANÇOIS \u2014 BAR OF SAINT FRANCIS Candidat pour l'admission à la pratique du droit Candidate for the admission to the practice of law Examena de juillet 1950 \u2014 Examination of July, 1960 Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tRésidence Residence \tPaul.\t28\tSherbrooke.\t\t\t Sherbrooke, le 23 mai 1950 \u2014 Sherbrooke, May 23, 1950.Le Secrétaire du Barreau de Saint-François, GUY BLANCHETTE, 27648-22-2-0 Secretary of the Bar of Saint Francis.Lettres patentes supplémentaires Compagnie Trudeau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 mai 1950, à la \"Compagnie Trudeau Ltée\", ratifiant son Règlement N° XXI: a) réduisant son capital-actions par l'annulation de 8,500 actions ordinaires de $10 chacune et de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune: b) augmentant son capital-actions par la création de 30,000 nouvelles actions privilégiées de $10 chacune sujettes aux droits, privilèges, restrictions et limitations indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 30 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 27652-0 L.DÉSILETS, Consolidated Rochette Mines Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a-cté accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 30 mai 1950, à la compagnie \"Rochette Gold Mines Company Limited\" (Li- Supplementary Letters Patent Compagnie Trudeau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the thirtieth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Compagnie Trudeau Ltée\", ratifying its By-law No.XXI: a) reducing its capital stock by the cancellation of 8,500 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $100 each; b) increasing its capital stock by the creation of 30,000 new preferred shares of $10 each subject to the rights, privileges, restrictions and limitations indicated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 27652 Deputy Attorney General.Consolidated Rochette Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Rochette Gold Mines Company Limited\" (No 1556 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1950, Tome 82, N° 22 bre dc responsabilité personnelle), constituée en Personal Liability), incorporated under the corporation eu vertu de la Loi des compagnies Quebec Mining Companies Act by letters patent minières de Québec par lettres patentes en date dated July 8, 1930, and by supplementary letters du 8 juillet 1936, et par lettres patentes supplé- patent dated May 23, 1950, changing its name mcntaircs en date du 23 mai 1950 changeant son into that of \"Consolidated Rochette Mines Ltd.\" nom ell celui de \"Consolidated Rochette Mines (No Personal Liability).Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle).Daté du bureau du Procureur général, le 30 Dated at the office of the Attorney General, mai 1950.the 30th day of May, 1950.L'Assistant-procureur général.L.DÉSILETS, 27652 L.DÉSILETS.27652-o Deputy Attorney General.Nomination Appointment Jl a plu a Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, (le l'avis et du consentement du Conseil exécutif, et par commission, dc faire la nomination suivante: IIis Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, to make the following appointment: Québec, 3 mai 1950.Quebec, May 3, 1950.M.Henri Monty, avocat, conseil eu loi de Sa Mr.Henri Monty, advocate, King's Counsel, Majesté, de la cité de Montréal: recorder à la of the city of Montreal: to be Recorder for the Cour du recorder'de la cité de Montréal, à comp- Recorder's Court of the City of Montreal, as ter du 10 mai 1950.from the 10th day of May, 1950.27649-0 27049 Proclamation Proclamât ion Canada, Province de EUG.PISLT Québec.IL.S.] GEORGE VI, par la grâce de Dieu, Hoi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'iccllcs pourront concerner.Salut.PROCLAMATION L'Assistant-procureur i ATTENDU que lors ornerai, » ('(' ':l dernière ses- L.désilets.vsion «h* la Législature de Québec, là charte de l'Université de Montréal a été refondue et améliorée par le bill N° 09 (11 George VI, chapitre 1 12); attendu que cette loi entre en vigueur à la date qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation; Attendu que Son Excellence Mgr l'Archevêque de Montréal, (pli est de droit chancelier de l'Université de Montréal, a exprimé au Premier ministre de la province le désir que cette loi soit mise en vigueur dès les premiers jours de juin prochain; Attendu qu'il y a lieu de fixer au cinq juin 1950, la date de l'entrée en vigueur de cette loi; A ces causes, de l'avis et du consentement de Notre Conseil Exécutif, exprimé dans l'arrêté en conseil numéro 590, du 31 mai 1950, et conformément aux dispositions de la loi concernant la charte dc l'Université de Montréal (14 George VI, chapitre 142), Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons (pie la date de l'entrée en vigueur de la loi 14 George VI, chapitre 142.intitulée \"Loi concernant la charte de l'Université de Montréal\", soit fixée au cinq juin 1950.( ïanada, Province of EUG.FISET Quebec.[L.S.] GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain.Ireland and the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.PROCLAMATION L.désilets, IV\\7\"HKREAS at the last Deputy Attorney < session of the Quebec General.(.Legislature, the charter of the University of Montreal was revised and improved by Rill No.09 (14 George VI, chapter 142); Wiieueas the said Act conies into force on such date as the Lieutenant-Governor in Council may be pleased to fix by proclamation; Wiieueas His Excellency the Archbishop of Montreal, who is of right the chancellor of the University of Montreal, has expressed to the Prime Minister of the Province the desire that the said Act be put into force early in June next; Wiieueas it is expedient to fix to the fifth day of June, 1950, the date of the coming into force of the said Act; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in the Order in Council No.590 of the 31st of May, 1950, and pursuant to the provisions of the Act respecting the charter of The University of Montreal (14 George VI, chapter 142), We have enacted and ordered and do hereby enact and order that the date of the coming into force of the Act 14 George VI, chapter 142, intituled \"An Act respecting the charter of The University of Montreal\", be fixed to the fifth day of June, 1950. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1557 De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur [celles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé le Major-général l'honorable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt., C.M.G., D.S.O., M.D., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce trente et unième jour de mai en l'année mil neuf cent cinquante de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatorzième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 27647-0 JEAN BRUCHÉSI.Sièges sociaux AVIS Mountain Chest Mines, Limited (L.R.P.) Par résolution du bureau de direction, le siège social de la compagnie \"Mountain Crest Mines, Limited\", l.r.p.sera à 1555 rue Mackay, en la cité dc Montréal.Montréal, 1er mai 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 27627 ANT.B.HAMELIN.Henri Hauwood & Compagnie (Ltée) Avis est donné que la compagnie \"Henri Harwood & Compagnie (Ltée)\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 2'2ième jour de janvier 1949, et ayant son bureau principal dans la cité et le district de Montréal, a établi son bureau au numéro 257 est de la rue Des Commissaires.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme é tant son bureau principal.Donné à Montréal, ce Sième jour de mai 1950.Le Secrétaire-trésorier, 27(>39-o CLAUDE HARWOOD.Canada.Province de Québec, District de Québec Capitol Jewellers Inc.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Capitol Jewellers Inc.\", une compagnie constituée en corporation par lettres patentés en date du 25 janvier 1950, et ayant son siège social en la cité dc Québec, a établi son bureau au N° 198, rue St-Jean, cité de Québec.A compter de la date dc cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Québec, le 1er février 1950.Le Secrétaire, 27646 PHILO TALBOT.Of all of Which our loving subjects and all others, whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony Whereof, We have caused these Our Letters to l>e made Patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved Major (icneral, the Honourable Sir EUGENE-MARIE-JOSEPH FISET, Kt., C.M.G.D.S.O.M.D., Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec in Our Province of Quebec this thirty-first day of the month of May, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and fifty, and the fourteenth year of Our Reign.By command, JEAN BRUCHÉSI, 27047 Under Secretary of the Province.Head Offices NOTICE Mountain Crest Mines, Limited (N.P.L.) By resolution of the Board of Directors, the Head-Office of \"Mountain Crest Mines, Limited,' ' n.p.l., will be at 1555 Mackay Street, in the City of Montreal.Montreal, May 1st, 1950.(Seal) ANT.B.HAMELIN, 27027-o t Secretary.Henri Harwood & Compagnie (Ltée) Notice is given that the company \"Henri Harwood & Compagnie (Ltée)\" incorporated by letters patent dated the 22nd day of January, 1949, and having its head office in the city and district of Montreal, has established its office at No.257 des Commissaires street East.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 8th day of May, 1950.CLAUDE HARWOOD, 27(539 Secretary-Treasurer.Canada, Province of Quebec, District of Quebec Capitol Jewellers Inc.Notice is hereby given that the \"Capitol Jewellers Inc.\", company incorporated by Letters Patent on the 25th of January 1950, having its head-office in the City of Quebec, has established its office at no.198, St.John Street, Quebec City.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head-office of the company.Dated at Quebec this 1st day of February 1950.PHILO TALBOT, 27046-o Secretary. 155S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1950, Tome 82, N° 22 Canada, Province de Québec, Bedford District tie Canada, Province of Quebec, District of Bedford In re: Eastern Wiiitewear Company Limited In re: Eastern Wiiitewear Company Limited Règlement changeant l'endroit «lu siège social A By-law changing the location of the Head Office Règlement A'° 17 \"Qu'il soil décrété et il est par les présentes décrété comme règlement de la \"Eastern White-wear Company Limited\" que l'endroit du siège social dc la compagnie soit et ledit endroit est par les présentes changé et transporté du N° 42 de la rue Dépôt, dans la ville de Farnham, à Notre-Dame de Stanbridgo, comté de Missisquoi, dans la province de Québec.\" Certifié copie exacte.Farnham, ce 13 mai, 1950.(Sceau) Le Président, AIMÉ FOURNIER, Le Secrétaire, 27620-o NAPOLÉON MESSIER.By-Law No.17 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of the \"Eastern Wiiitewear Company Limited\" that the location of the head office of the company be and the same is hereby changed and moved from No.42 Dépôt street, in the Town of Farnham, to Notre-Dame de Stanbridge, county of Missisquoi, in the Province of Quebec\" Certified true copy.Farnham, May 13, 1950.(Seal) AIMÉ FOURNIER, President.NAPOLÉON MESSIER, 27029 Secretary.Soumissions Tenders Province de Québec La Commission scolaire protestante de Onslow (Comté de Pontine) Avis public est, par les présentes donné (pic des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Helfti I*.Campbell, secrétaire-trésorier, Beech (irove, comté de Pontiac, jusqu'à 8 heures p.m., le 21ième jour de juin 1950, pour l'achat de §105,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles protestantes de la municipalité dc Onslow datées du 2 juillet 1950 et remboursables par séries du 2 juillet 1951 au 2 juillet 1900 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3J/£% par année payable semi-annuellement le 2 juillet et le 2 janvier dc chaque année.L'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou peut varier suivant les échéances.Le tableau «l'amortissement est le suivant: Province of Quebec The Protestant School Commission of Onslow (County of Pontiac) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Helen P.Campbell.Secretary-Treasurer, Beech Grove, county of Pontiac, up to 8 o'clock P.M., on the 21st day of June 1950, for the purchase of $105,000.00 of bonds of the Protestant School Commissioners for the Municipality of Onslow, dated July 2nd, 1950 and redeemable serially from July 2nd, 1951 to July 2nd, 1900 inclusively, with interest at a rate not exceeding 33^2% per annum payable semi-annually the 2nd day of July and the 2nd day of January of each year.The interest may be the same for the total issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 §105,000.00 \u2014 10 ans Table of redemption \u2014 $105,000.00 \u2014 10 years Année Capital 2 juillet 1951.x §18,500.00 2 juillet 1952.x 19,500.00 2 juillet 1953.x 20,000.00 2 juillet 1954.x 21,000.00 2 juillet 1955.2 juillet 1950.2 juillet 1957.2 juillet 1958.2 juillet 1959.2 juillet 1900.4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 Year July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, July 2nd, Capital 1951.x 818,500.00 1952.x 19,500.00 1953.1954.1955.1950.1957.1958.1959.1960.20,000.00 21,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 Les x indiquent les années durant lesquelles un octroi, au montant total dc $70,000.00 accordé par le Secrétaire dc la Province et payable en quatre versements de $17,500.00 chacun, de 1951 à 1954 inclusivement, sera reçu et appliqué au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts seront payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, Québec ou Quyon, comté dc Pontiac.The letters x indicate the year during which a grant, to the total amount of $70,000.00.granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of $17,500.00 each, from 1951 to 1954 inclusively, will be received and applied to the use of such loan.Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or Quyon, county of Pontiac. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1559 Ces obligations peuvent, sous l'autorité du chapitre 212 des statuts refondus de Québec 1941, être rachetées .par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute date d'échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant total de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une assemblée des commissaires d'écoles, qui sera tenue mercredi le 21 juin 1950, à 8 heures p.m., à l'école publique de Quyon.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Daté à Onslow, comté de Pontiac, le 30ième jour de mai 1950.Le Secrétaire-trésorier, HELEN P.CAMPBELL, Beech Grove, 27040 comté dc Pontiac, P.Q.$150 Tableau d'amortissement Année 2 juillet 1951.x 2 juillet 1952 .x 2 juillet 1953 .x 2 juillet 1954 .x 2 juillet 1955 .x 2 juillet 1956 .2 juillet 1957 .2 juillet 1958 .2 juillet 1959 .:.2 juillet 1960 .2 juillet 1961.2 juillet 1962 .2 juillet 1963 .2 juillet 1964 .2 juillet 1965 .2 juillet 1966 .\u201e 2 juillet 1967 .2 juillet 1968 .2 juillet 1969 .2 juillet 1970 .,000 \u2014 20 ans Capital 19,000.00 19,500.00 20,500.00 21,000.00 21,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 These bonds may, under the authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest payment date; however, if such redemption be partial the bonds to be redeemed will be called in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amount of the loan, and must specify whether the price offered includes or docs not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners, to be held on Wednesday, June 21st, 1950, at 8 o'clock, P.M., at the Quyon Public School.The Commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Dated at Onslow, county of Pontiac, the 30th day of May, 1950.HELEN P.CAMPBELL, Secretary-Treasurer, Beech Grove, 27640-o County of Pontiac, P.Q.Province de Québec Commission scolaire de l'Immaculée-Conception de Laciiute-Mills (Comté d'Argenteuil) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Ed.Lavoie, secrétaire-trésorier, C.P.200, Lachute-Mills, comté d'Argenteuil, jusqu'à 8 heures p.m., mardi le 20 juin 1950, pour l'achat dc $150,000 d'obligations de la commission scolaire de lTinmaculée-Conception de Lachute-Mills, datées du 2 juillet 1950 et remboursables par séries du 2 juillet 1951 au 2 juillet 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3^% par année payable semi-annuellement les 2 janvier et 2 juillet dc chaque année.L'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Province of Quebec School Commission of l'Immaculée-Conception de Lachute-Mills (County of Argenteuil) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Ed.Lavoie, secretary-treasurer, P.O.Box 260, Lachute-Mills, county of Argenteuil, up to 8 o'clock p.m., Tuesday the 20th day of June, 1950, for the purchase of $150,000 of bonds of the school commission of l'Immaculée-Conception de Lachute-Mills, dated the 2nd of July, 1950, and redeemable serially from the 2nd of July 1951 to the 2nd of July 1970 inclusive, with interest at a rate not exceeding 3j^% per annum, payable semi-annually the 2nd of January and 2nd of July of each year.Interest may be the same for the total issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $150,000 \u2014 20 years Year Capital Kf July 2nd, 1951.x $ 19,000.00 \" July 2nd, 1952 .x 19,500.00 July 2nd, 1953 .x 20,500.00 July 2nd, 1954 .x 21,000.00 July 2nd, 1955 .x 21,500.00 July 2nd, 1956 .2,500.00 July 2nd, 1957 .2,500.00 July 2nd, 1958 .2,500.00 July 2nd, 1959 .3,000.00 July 2nd, 1960 .3,000.00 July 2nd, 1961 .3,000.00 July 2nd, 1962 .3,000.00 July 2nd, 1963 .3,000.00 July 2nd, 1964 .3,500.00 July 2nd, 1965 .3,500.00 July 2nd, 1966 .3,500.00 July 2nd, 1967 .3,500.00 July 2nd, 1968 .4,000.00 July 2nd, 1969 .4,000.00 July 2nd, 1970 .4,000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles The letters x indicate the years during which les versements d'un octroi au montant total de payments of a grant to the total amount of $100,000, accordé par le Secrétaire de la Province $100,000, from the Provincial Secretary and 1500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 juin 1950, Tome 82, N\\22 et payable en cinq versements de §20,000 chacun, de 1051 à 195S inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Lachute, comté d'Argenteuil.Ces obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 «les Statuts refondus «le Québec, 1911, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance «l'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il all'ectera les échéances les plus éloignées et les numéros les pluS élevc's.Choque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% «lu montant total dc l'emprunt et devra spécifier si le prix oll'ert comprend ou ne comprend pus les intérêts accrus sur les obligations au moment «le leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «le la commission scolaire qui sera tenue le 20 juin 1950, à 8 heures p.m., à l'école «le l'Immaculée-Conception', à Lachute-Mills.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Daté à Lachute-Mills, comté d'Argenteuil, ce 1er juin 1950.Le Secrétaire-trésorier, ED.LAVOIE, CP.200, Lachute-Mills, 27050-o Cté d'Argenteuil, P.Q.payable in five instalments of $20,000 each, from 1951 to 1955 inclusive, will be rcceive«l and applied to the use of this loan.Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Lachute, county of Argenteuil.The sai«l bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest payment date, under authority of chapter 212 of the llevisctl Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial the bonds to be redeemed will be called in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the total amount of the loon ami must specify whether the priée offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commission to be held on the 20th of June, 1950, at 8 o'clock p.m., in the \"Immaculée-Conception\" school, at Lachute-Mills.The commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Dated at Lachute-Mills, county of Argenteuil, this 1st day of June, 1950.ED.LAVOIE, Secretary-Treasurer, P.O.Box 200, Lachute-Mills, 27656 County of Argenteuil, P.Q.Province «le Québec Province of Quebec Village de Plessisville (Comté de Mégantic) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné à son bureau à l'Hôtel «le ville de Plessisville, jusqu'à 8 heures p.m., lundi le 19 juin 1950, pour l'achat de $70,000.00 d'obligations dc la municipalité «lu village de Plessisville, comté dc Mégantic, datées «lu 1er juillet 1950 et remboursables par séries du 1er juillet 1951 au 1er juillet 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3%% par année, payable scmi-annucllemcnt les 1er juillet et 1er janvier de chaque année.L'intérêt offert peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Village of Plessisville (County of Mégantic) Public notice is hereby given that sealed tenders, eudorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned at his office in the Town Hall of Plessisville, until 8 o'clock p.ni., on Monday, June 19, 1950, for the purchase of $70,000.00 of bonds of the municipality of the Village of Plessisville, county of Mégantic, dated July 1st, 1950, and redeemable serially from July 1st, 1951, to July 1st, 1970 inclusively, with interest at a rate not exceeding 3]^% per annum, payable semi-annually on July 1st, and January 1st of each year.The interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $70,000.00 \u2014 20 ans Table of redemption \u2014 $70,000.00 \u2014 20 years Année Capital 1951.$2,500.00 1952.2,500.00 1953 .2,500.00 1954 .2,500.00 1955 .3,000.00 1956 .3,000.00 1957 .3,000.00 1958 .3,000.00 1959 .3,000.00 1960 .3,500.00 1961.\u2022.4,500.00 1962 .4,500.00 1963.5,000.00 1964 .5,000.00 1965 .5,000.00 1966 .3,500.00 1967 .3,500.00 Year Capital 1951.$2,500.00 1952 .2,500.00 1953 .2,500.00 1954 .2,500.00 1955 .3,000.00 1956.3,000.00 1957 .3,000.00 1958 .3,000.00 1959.3,000.00 1960 .3,500.00 1961.v.4,500.00 1962 .4,500.00 1963.5,000.00 1964 .5,000.00 1965 .5J300.00 1966 .3,500.00 1967 .\" 3,500.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1561 1968.3,500.00 1969.3,500.00 1970.3,500.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec, ou à Plessisville.Lcsditcs obligations pourront, en vertu des dispositions du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pus les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du Conseil qui sera tenue le 19 juin 1950, à 8 lires p.m., à la salle de l'hôtel de ville de Plessisville.Le Conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Plessisville, ce 30ième jour de niai, 1950.Le Secrétaire-trésorier, MARCEL COLLIN.Hôtel de Ville, Plessisville, 27655-0 Comté de Mégantic.1968 .3,500.00 1969 .3,500.00 1970.3,500.00 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure in Montreal, in Quebec or in Plessisville.The said bonds may, under authority of Chapter 212 Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, on any interest payment date, at par; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by certified cheque, equal to 1% of the total amount of the loan and must specify whether the price offered includes or docs not include accrued interest on the bonds to the date of their delivery.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council, Monday the 19th day of June, 1950, at 8 o'clock p.in., at the Town Hall.The Council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Plessisville, this 30th day of May 1950.MARCEL COLLIN, Secretary-Treasurer, Town Hall, Plessisville, 27655-0 County of Mégantic.Ventes \u2014 Loi de faillite Canada, Province de Québec, District de Ri-inouski, ('our supérieure, N° 11,474.(Siégeant en matière de faillite).Hobcrt-G.Gagnon, garagiste, Cap-Chat, P.Q., failli, et Henri-A.Martin, Syndic.Avis public, est par le présent donné que les terres et héritages sous mentionnés seront vendus aux temps et lieu respectifs, tel que mentionné plus bas.\"Une terre sise et située au premier rang de la paroisse dc St-Norbert de Cap-Chat, mesurant une largeur de dix chaînes et dix-sept chaînons, équivalent à trois arpents et demi, sur une profondeur dc quatre-vingt-dix-sept chaînes, avec maison, garage, entrepôt, boutique à bois et boutique de forge et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, connue et désignée comme étant les lots portant les numéros cinquante-deux subdivision A et cinquante-deux subdivision B (52-A et 52-B) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le canton Cap-Chat et bornée comme suit: vers le nord-ouest, par le Golfe St-Laurent, vers le nord-est, par le lot 51-D, de Dame Joseph Gagnon, vers le sud-est, par la ligne de division entre le premier rang et le petit rang Pointe Cap-Chat et vers le sud-ouest par le lot 52-D de Sieur Albert et René Gagnon, sauf à distraire du lot 52-B les emplacements vendus par Robert Gagnon à Messieurs Roland Gagnon, Luc Savoie, Joseph Gagné, Eustache Landry, et Joseph Savoie, aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement de Stc-Anne des Monts sous les numéros 8641, 9777, 8874, 9164 et 9165.\" Pour être vendue sur les lieux à Cap-Chat, le VIXGT-NEUVEEME jour de JUIN 1950 à DIX heures de l'avant-midi (heure avancée).Sales \u2014 Bankruptcy Act Canada, Province of Quebec, District of Ri-niouski, Superior Court, No.11,474.(Sitting in Bankruptcy).Robert G.Gagnon, garage keeper, Cap-Chat, P.Q.insolvent; & Henri A.Martin, Trustee.Public notice is hereby given that the lands and hereditaments mentioned below will be sold at the respective time and place as mentioned below.A farm situate and lying in the first range of the parish of St-Norbert de Cap-Chat, measuring a width of ten chains and seventeen links, equivalent to three arpents and one half, by a depth of ninety-seven chains\u2014with the house, garage, warehouse, wood workshop and forge and other buildings thereon erected, circumstances and dependencies, known and designated as being the lots bearing numbers fifty-two subdivision A and fifty-two subdivision B (52-A and 52B) on the official cadastral plan and in the book of reference for the township of Cap-Chat, and bounded as follows: towards the northwest, by the Gulf of St.Lawrence, towards the northeast, by lot 51-D, belonging to Dame Joseph Gagnon, towards the southeast, by the division line between the first range and the \"petit rang Pointe Cap-Chat\" and towards the southwest by lot 52-D belonging to Sieur Albert and René Gagnon, save to be deducted from lot 52-B the emplacements sold by .Robert Gagnon to Messrs.Roland Gagnon, Luc Savoie, Joseph Gagné, Eustache Landry and Joseph Savoie, under the terms of deeds registered in the Registry Office of Ste-Annc des Monts under Nos.8641, 9777, 8874, 9164 and 9165.\" ¦ To be sold on the premises at Cap-Chat, on the TWENTY-NINTH day of JUNE, 1950, at TEN o'clock of the forenoon (Daylight Saving Time). 15G2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 8 juin I960, Tome 82, Nù 22 Cette vente aura le même effet qu'une vente faite par le shérif.Rimouski, Que., ce 25ième jour de mai 1950.Le Syndic Licencié.HENRI-A.MARTIN.Bureau: 152A, de l'Évêché, Rimouski, Que.27579-2 l-2-o Canada, province de Québec, district de Québec.Cour Supérieure (en matière de faillite).VENTE A L'ENCAN Dans l'affaire de l'actif de: Wilfrid Vallée, hôtelier, Saint-Côme, comté de Beauce, cédant autorisé.Avis est par le présent donné que: LUNDI DOUZE JUIN 19o0.à 10.30 heures a.m., sera vendu par encan public, à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Côme, comté de Beauce, l'immeuble de cette faillite décrit comme suit: o) Un emplacement situé en la paroisse de Saint-Côme, comté dc Beauce, avec tous les droits et prétentions y attachés antérieurement avec hôtel et bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; ledit emplacement est compris dans les bornes et délimitations suivantes: savoir: en front, au chemin publie, au nord-ouest à la route, au nord-est à un chemin privé, et au sud-est borné par Siméon Paquet ou représentants, étant ledit emplacement les lots numéros quarante et un huit, quarante et un dix et partie de quarante et un neuf (41-8, 41-10 et partie 41-9) du cadastre officiel pour le premier rang du canton Linière, à compter d'Aubin de l'Lsle, sujet à la rente existante.L'item a l'immeuble sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur et conformément aux articles 71 G, 717 et 719A du C.P.C.et aussi à l'article 45 de la Loi de Faillite, cette vente équivaut à la vente au Shérif.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant au soussigné.La propriété offerte en vente peut être visitée en tout temps en s'adressant au soussigné.Toutes personnes désirant .enchérir lors dc la vente devront déposer avant la vente, entre les mains du syndic, une somme de trois mille piastres ($3,000.00) en argent ou chèque accepté.Condition de paiement: Argent comptant.Québec, ce 2ième jour de mai 1950.Le Syndic, LOUIS ROBERT RUEL.Bureaux: 107 rue Commercial, Lévis, Que.27489-18-2-0 Canada, Province de Québec Division de Faillite N° 5 pour les districts judiciaires de Trois-Rivières et -de Nicolct.Dans l'affaire dc: Maurice Adam Jourdain, garagiste de Grand'Mère, district des Trois-Rivières, cédant autorisé.Avis public est par les présentes donné que l'immeuble désigné comme suit: \"Un terrain anciennement de Ste-Flore, actuellement dans les limites de la Cité dc Grand'Mère, mesurant un demi-arpent de largeur sur la profondeur d'un arpent; borné en \"front par le second rang Ste-Catherine, aujourd'hui sixième avenue ou rue Ste-Catherine, en profondeur et d'un côté par le terrain de J.A.Paquin, représentant Adé-lard Gélinas et d'autre côté par le terrain de Vin- The said sale to have the same effect as a Sheriff's Sale.Rimouski, Que., this 25th day of* May, 1950.HENRI A.MARTIN, Licensed Trustee.Office: 152A, de l'Évêché, Rimouski, Que.27579-21-2 Canada, Proviuce of Quebec, District of Quebec, Superior Court (sitting in Bankruptcy).AUCTION 6ALE In the matter of the estate of: Wilfrid Vallée, hotclkeeper, Saint-Côme, county of Beauce, authorized assignor.Notice is hereby given that on MONDAY the TWELFTH day of JUNE, 1950.at 10.30 o'clcck a.m., there will be sold by public auction, at the church door of the parish of Saint-Côme, county of Beauce, the immovable of this estate described as follows: a) An emplacement situate in the parish of Saint-Côme, county of Beauce, with all the rights and pretentions heretofore attached thereto with the hotel and buildings thereon erected, circumstances and dependencies; the said emplacement is comprised within the following boundaries and limits, to wit: in front, by the public road, on the northwest by the highway, on the northeast by a private road, and on the southeast by Siméon Paquet or representatives, being, the said emplacement lots numbers forty-one eight, forty-one ten and part of forty-one nine (41-8, 41-10 and part 41-9) on the official cadastre for the first range of the township Linière, starting from Aubin de ITsle, subject to the existing rent.Item a of the immovable will be sold to the highest and last bidder and pursuant to articles 716, 717 and 719A of the C.C.P., and also section 45 of the Bankruptcy Act, the said sale to have the effect of a Sheriff's sale.The titles and certificates may be seen at any time by applying to the undersigned.' The property offered for sale may be seen at any time by applying to the undersigned.Any person desiring to bid at the time of the sale must deposit with the trustee, before the sale, a sum of three thousand dollars ($3,000) in cash or by an accepted cheque.Condition of payment: Cash.Quebec, this 2nd day of May, 1950.LOUIS ROBERT RUEL, Trustee.Offices : 107 Commercial St., Levis, Que.27489-18-2-0 Canada, Province of Québec Bankruptcy Division No.5 for the judicial districts of Trois-Rivières and Nicolet.In the matter of: Maurice Adam Jourdain, garage keeper of Grand'Mère, district of Trois-Rivières, authorized assignor.Public notice is hereby given that the immovable described as follows: \"A lot of laud heretofore of Ste-Flore, actually within the limits of the City of Grand'Mère, measuring one half arpent in width by one arpent in depth; bounded in front by the second Sle-Cathcrine range, now sixth avenue or Ste-Catherine street, in depth .and on one side by the land of J.A.Paquin, representing Adélard Gélinas and on the other side by the land of Vincent QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 3rd, 1950, Vol.82, No.22 1563 cent et Lampron, représentant Dame Dontigny ot Georges Dontigny; faisant partie
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.