Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 14 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1950-10-14, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 82, N° 41 2555 Vol.82, No.41 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Ceo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebee adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.S) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Québec Officiai Gazette (published by the provincial govern ment) PROVINCE DE QUÉBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 14 octobre 1950\tQuebec, Saturday, October 14th, 1950 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official x \" rates.3° Specifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates fiant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion : otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme without prejudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Québec Officiai Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-claue, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 2556 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, IL octobre 1950, Tome 82, N° Il délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la (mblication de certains documents, à cause de leur ongueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à*celui du nombre d'insertions, et 'la lettre \"o\" signifie Sue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not- received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion:_15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.I Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439-1-52 Lettres patentes A.Barsctti & Manucci Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier septembre 1950, constituant en corporation : Angelo Barsetti, statuaire, Arsène Manucci, artiste-peintre, Dominique Barsetti, * commis-comptable, et Louis Barsetti, mouleur, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Opérer une manufacture de statues et d'ornementations d'églises sous le nom de \"A.Barsetti & Manucci Inc.\", avec un capital de 825,000 divisé en 250 actions communes d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 111, 3ième avenue, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le premier septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Letters Patent A.Barsetti & Manucci Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of September 1950, incorporating: Angelo TJarsetti, statuary, Arsène Manucci, artist-painter, Dominique Barsetti, clerk and accountant, and Louis Barsetti, moulder, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate a factory for the making of statues and church ornaments, under the name of \" A.Barsetti & Manucci Inc.\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at 111 3rd avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lAth, 1950, Vol.82, No.Al 2557 Administration Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit septembre 1950, constituant en corporation: Bernade Charette, comptable, Martine Ranger et Pauline Cabana, sténographes, toutes des cités et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Gérer et administrer les opérations et affaires de toute compagnie, firme ou individu, sous le nom de \"Administration Inc.\", avec un capital de $25,000 divisé en 6,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit septembre 1950.L'Assistant-procureur généra], 2S503 L.DÉSILETS.A.J.Campbell & Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six septembre 1950, constituant en corporation: William Bernard Cain, avocat, Joan Evelyn Edgley, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, Lillian Mary Lynch, épouse séparée de biens de Ambrose J.Campbell, ménagère, et dûment autorisée par lui, tous deux de la cité d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et les affaires de manufacturiers et commerçants d'attaches de toutes espèces, spécialités pour le génie, produits et pièces pour icelui, alliages de fer, acier et métaux de toutes sortes, équipement de chemin de fer, produits chimiques, polis d'automobile et de bijouterie, enduits et finissages de toute description, sous le nom de \"A.J.Campbell & Co.Limited\".Le capital de la compagnie est divisé en huit cents (800) actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant de capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de quatre mille dollars ($4,000).Le siège social de la compagnie sera à Outre-mont, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.Amos Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept septembre 1950, constituant en corporation: Lucippe Hivon, gérant, Lucien Crevier, électricien, Dame Royaula Massicot te, épouse contract uellement séparée de biens de Lucippe Hivon, et Léo Tremblay, électricien, tous d'Amos, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes d'appareils et matériaux et accessoires électriques, sous le nom de \"Amos Electric Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Administration Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Comapnies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of September, 1950, incorporating: Bernade Charette, accountant, Martine Ranger and Pauline Cabana, stenographers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manage and administer the business and affairs of any company, firm or individual, under the name of \"Administration Inc.\", with a capital stock of $25,000 divided into 6,000 common shares of a par value of $1 each and 3,800 preferred shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.A.J.Campbell & Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of September, 1950, incorporating: William Bernard Cain, advocate, Joan Evelyn Edgley, secretary, both of the City of Montreal, Lillian Mary Lynch, wife separate as to property of Ambrose J.Campbell, housewife, and duly authorized by him, both of the City of Outremont, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and trade of manufacturers and dealers of fasteners of every kind, engineering specialties, products and parts, iron, steel and metal alloys of every kind, railroad equipment, chemicals, automobile and jewellery polishes, coatings and finishes of every description, under the name of \"A.J.Campbell & Co.Limited\".The capital stock of the company is divided into eight hundred (800) shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be four thousand dollars ($4,000.00).The head office of the company will be at Outremont, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Amos Electric Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of September, 1950, incorporating: Lucippe Hivon, manager, Lucien Crevier, electrician, Dame Royaula Massicotte, wife separate as to property by marriage contract of Lucippe Hivon, and Léo Tremblay, electrician, all of Amos, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of electrical appliances, materials and supplies, under the name of \"Amos Electric Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Amos, judicial district of Abitibi. 2558 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1A octobre 1950, Tome 82, N° Al Daté du bureau du Procureur général, le sept septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.Appartements Lucerne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a c'té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier septembre 1950, constituant en corporation: Geoffroy Birtz, Madeleine Béique, avocats, et Gabrielle Lahaie, seprétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles; agir comme constructeurs et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Appartements Lucerne Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1424, rue St-christophe, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général' le premier septembre 1950.- L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.Art.Aubry & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente août 1950, constituant en corporation: Arthur Aubry, maître plombier, Adélard Aubry, plombier, et Jean-René Alarie, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles sanitaires, de plomberie, de chauffage, de ventilation, matériel de construction, machineries quelconques et combustibles; entreprendre tous travaux de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de sanitation, sous le nom de \"Art.Aubry & Fils Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune, et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente août 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.Association des Agents d'Assurances .de Granby Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du vingt-trois août 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Georges Avery, Nelson H.Dunn, Gérard Racine, Louis Laporte et Gérard Cazeault, tous agents d'assurances, de la cité de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Constituer en un groupe puissant les agents d'assurances de Granby, développer chez eux un esprit de solidarité et promouvoir leurs intérêts intellectuels, sociaux et matériels, sous le nom de Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Appartements Lucerne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day cf September, 1950, incorporating: Geoffroy Birtz, Madeleine Béique, advocates, and Gabrielle Lahaie, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate; to act as builders and deal in building requisites, under the name of \"Appartements Lucerne Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1424 St-Christophe street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Art.Aubry & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, incorporating: Arthur Aubry, master plumber, Adélard Aubry, plumber, and Jean René Alarie, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sanitary supplies, plumbing, heating and ventilating supplies, building requisites, machinery of all kinds and fuel, to undertake plumbing, heating, ventilation or sanitation works, under the name of \"Art.Aubry & Fils Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 400 preferred shares of $100 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of August, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Association des Agents d'Assurances de Granby Notice is hereby given that under Part LTI of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the LieutenantTGovernor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of August, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Georges Avery, Nelson H.Dunn, Gérard Racine, Louis Laporte and Gérard Cazeault, all insurance agents, of the city of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes : To.form into a powerful group the insurance agents of Granby, to develop amongst them a spirit of fellowship and promote their intellectual, social and material interests, under the name of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lAth, 1950, Vol.82, No.Al 2559 \"Association des Agent d'Assurance de Granby\".Les pouvoirs de la compagnie ne permettent pas les jeux à l'argent, les jeux de hasard, ni les jeux mixtes de hasard et d'habileté, et ces pouvoirs n'autorisent pas la compagnie à demander détenir ou opérer une licence octroyée par la Commission des Liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 810,000.Le siège social de la corporation sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois août 1950.L'Assistant-procu reu r général, 28503-o L.DÉSILETS.Association des Tenanciers de maisons de logement Lodging House Keepers Asssociation lAvis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre août 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Doré, Levis Tardif, Robert Gilbert, Aimas Gagné et Dame Louisette F.Paradis, veuve de Paul Paradis, tous tenanciers licenciés de maisons de logements, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Protéger et défendre les intérêts économiques et professionnels des propriétaires licenciés de maisons de logement, sous le nom de \"Association des tenanciers de maisons de logement\" \u2014 \"Lodging House Keepers Association\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 8100,000.Le siège social de la corporation sera à Suite 312, 65 rue Sainte-Anne, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur généra], le quatre août 1950.L'Assistant-procureur général, 2S503-o L.DÉSILETS.\"Association des Agents d'Assurances de Granby\".The powers of the company do not permit gambling, games of chance or mixed games or chance and skill, and these powers do not authorize the company to apply for, hold or operate a license granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Association des Tenanciers de maisons de logement Lodging House Keepers Asssociation Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of August, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Paul Doré, Levis Tardif, Robert Gilbert, Almas Gagné and Dame Louisette F.Paradis, widow of Paul Paradis, all licensed lodging house keepers, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To protect and defend the economic and professional interests of licensed lodging house keepers, under the name of \"Association des tenanciers de maisons de logement\" \u2014 \"Lodging House Keepers Association\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Suite 312, 65 Ste-Annc street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of August, 1950._ L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Automatic Cigarettes Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le' Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier septembre 1950, constituant en corporation: Henri Dion, bourgeois, J.-Eloi Ger-vais, avocat, de Longueuil, et Jacqueline Lali-berté, sténographe, de la cité de Montréal, ainsi que Henri Dion, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tabac manufacturé, chocolats, bonbons, eaux gazeuses, et autre marchandises similaires et faire le commerce de vendeurs automatiques, sous le nom de \"Automatic Cigarettes Service Ltd.\", avec un capital de Si 25,000 divisé en 50,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une nominale de $25 chacune.N Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le premier septembre 1950.L'Assistant-procueur général, 28504-o L.DÉSILETS.Automatic Cigarettes Service Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued Fy the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of September, 1950, incorporating: Henri Dion, retired gentleman, J.Eloi Gervais, advocate, of Longueuil, and Jacqueline Laliberté, steno^* grapher, of the city of Montreal, and also Henri Dion, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufactured tobacco, chocolates, candies, aerated waters and other similar merchandise and to deal in automatic vending machines, under the name of \"Automatic Cigarettes Service Ltd.\", with a.capital stock of $125,000 divided into 50,000 common shares of nominal value of $1 each and 3,000 preferred shares of a nominal value of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1950.L.DÉSLLETS, 28503 Deputy Attorney General. 2560 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, IL octobre 1950, Tome 82, N° Àl Belle-Grace Inc.Belle-Grace Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenantigouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the sixth day du six septembre 1950, constituant en corpo- of September, 1950, incorporating: Israël Levine, ration: Israël Levine, marchand, Dame Bella merchant, Dame Bella Urtig, housewife, wife Urtig, \u2022 ménagère, épouse séparée de biens de separate as to property of Israël Levine, and Israël Levine et Morton Braunstcin, manufac- Morton Braunstein, manufacturer, all of the turier, tous des cité et district judiciaire de City and Judicial District of Montreal, for the Montréal, pour les objets suivants: following purposes: Exercer le commerce comme manufacturiers To carry on business as manufacturers and et marchands de manteaux, vêtements, cos- dealers in coats, clothing,' suits, cloaks and tumcs, mantes et vêtements de sport, sous le sportswear, under the name of \"Belle-Grace Inc.\", nom de \"Belle-Grace Inc.\", avec un capital de with a capital stock of $40,000.divided into 200 $40,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une preferred shares of the par value of $100 each, valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions and 200 common shares of the par value of $100.ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the Company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le six Dated at the office of the Attorney General septembre 1950.this sixth day of September, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, .28503 L.DÉSILETS.28503-o Deputy Attorney General.Benger Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier septembre 1950, constituant en corporation: Max Garmaise, Maurice J.Garmaise, Seymour Elkin, notaires, de la cité de Montréal et Jessie M.McWatters, secrétaire, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme locateurs et administrateurs d'immeubles, sous le nom de \"Benger Corp.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Benger Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of September, 1950, incorporating: Max Garmaise, Maurice J.Garmaise, Seymour Elkin, notaries, of the City of Montreal, and Jessie M.McWatters, secretary, of Verdun, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To act as real estate lessors and administrators, under the name of \"Benger Corp.\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at the City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o ' Deputy Attorney General.Benmar Realty & Investment Corporation Benmar Realty & Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Prov-vince de Québec, des lettres patentes en date du ince of Quebec, bearing date the eighth day of huit septembre 1950, constituant en corporation: September, 1950, incorporating: David Good-David Goodman, Jack Lightstone, avocats, Fran- man, Jack Lightstone, advocates, Frances Wal-ces Walters, secrétaire, Imelda Langlois, commis, ters, secretary, and I meld a Lan gl ois, clerk, both toutes deux filles majeures, tous des cité et dis- spinsters, all of the City and Judicial District of trict judiciaire de Montréal, pour les objets sui- Montreal, for the following purposes: vants: Acquérir une certaine propriété immobilière, et To acquire and deal with a certain immoveable en faire le commerce sous le nom de \"Benmar property, under the name of \"Benmar Realty & Realty & Investment Corporation\", avec un Investment Corporation\", with a capital stock capital de $40,000 divisé en 200 actions privilé- of $40,000 divided into 200 preferred shares of a giées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 par value of $100 each, and 200 common shares of actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 a par value of $100 each, chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont-district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le huit Dated at the office of the Attorney General, septembre 1950.\u2022 this eighth day of September, 1950.L'Assistant-procureur généraPsuppléant, C.-E.CANTIN, 28503 C.-E.CANTIN.28503-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lAtk, 1950, Vol.82, No.Al 2561 Café Pagoda Inc.Cafe Pagoda Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the third day du trois juillet 1950, constituant en corporation: of July, 1950, incorporating: Paul Gait Michaud, Paul Gait Michaud, avocat, Carmen Geoffroy advocate, Carmen Geoffroy and Louise Héon, et Louise Héon, sténographes, tous des cité et stenographers, all of the city and judicial district district judiciaire de Montréal, pour les objets of Montréal, for the following purposes: suivants: Exercer le commerce d'hôtelier et de restau- To carry on the business of hotel and restaurateur, sous le nom de \"Café Pagoda Inc.\", avec rant keeper, under the name of \"Café Pagoda un capital de $75,000 divisé en 750 actions de Inc.\", with a capital stock of $75,000 divided into S100 chacune.750 shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le trois Dated at the office of the Attorney General, juillet 1950.m this third day of July, 1950.L'Assistant-procureur général, .L.DÉSILETS, 2S503-o L.DÉSILETS.28503 Deputy Attorney General.Cécile Valois Inc.Cécile Valois Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the fifth day du cinq septembre 1950, constituant en corpo- of September, 1950, incorporating: Paul Gait ration: Paul Gait Michaud, avocat, Gretta Michaud, advocate, Gretta Wainwright, and Wainwright et Louise Héon, sténographes, tous Louise Héon, stenographers, all of the city and des cité et district judiciaire de Montréal, pour les judicial district of Montreal, for the following objets suivants: purposes: Faire le commerce de vêtements de toutes To deal in garments of every kind and in all sortes et de tous accessoires de toilette, sous le toilet accessories, under the name of \"Cécile nom de \"Cécile Valois Inc.\", avec un capital Valois Inc.\", with a capital stock of $50,000, de 850,000 divisé en 500 actions de 8100 chacune, divided into 500 shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, .The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montréal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq Dated at the office of the Attorney General, septembre 1950.this fifth day of September, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28503-o L.DÉSILETS.28503 Deputy Attorney General.Club Kinsmen Alouette Montréal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six septembre 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Galt Michaud avocat, Gretta Wainwright, Louise Héon filles majeures usant de leurs droits, sténographes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Favoriser l'adoption et l'application d'un idéal plus élevé dans le domaine social, commercial ou professionnel, sous le nom de \"Club Kinsmen Alouette Montréal, Inc.\" Le montant des biens immobiliers de la corporation ou les revenus en provenant sera limité à cent mille dollars $100,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.Comité des Chemins d'Hiver de Proulxville, Inc.Avis ^st donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant- Club Kinsmen Alouette Montréal Inc.Notice is hereby given that under Part IH of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of September 1950, to incorporate as a corporation without share capital : Paul Gait Michaud, advocate, Gretta Wainwight, Louise Héon, spinsters in use of their rights, stenographers, all of the city and judicial district of Montreal,, for the following purposes: To promote the adoption and application of a higher ideal in the social, commercial or professional domain, under the name of \"Club Kinsmen Alouette Montreal Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold, or the revenue derived therefrom, is to be limited, is one hundred thousand dollars ($100,000).The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Comité des Chemins d'Hiver de Proulxville, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 2562 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 octobre 1950, Tome 82, N° Il gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en\" date du trente août 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph Chateauneuf, Adelphis Lefebvre, Aristide Fraser, contracteurs, Louis Lafrance, épicier-boucher, Gérard Goulet, épicier-boucher, et Gérard Crête, industriel, tous de Proulxville, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: S'occuper de l'entretien et de la réparation des chemins durant la saison des neiges, sous le nom de \"Comité des chemins d'hiver de Proulxville, Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $3,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Sévérin-de-Proulxville, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le trente août 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.Cost and Management Institute Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept septembre 1950, constituant en corporation sans capital actions: J.Grundy, trésorier, de Sherbrooke, H.J.Moffat, secrétaire-trésorier, de Lennoxville, tous deux du district judiciaire de St-François, J.B.A.Mé-rineau, vérificateur, J.G.Mock, trésorier, Perry W.Wright, secrétaire-trésorier, A.V.Madge, secrétaire-trésorier, V.Davies, comptable, C.P.Dumas, gérant, tous de Montréal, A.S.Keiller, auditeur-général, de Westmount, F.W.Naylor, comptable, de Verdun, Paul Kellogg, président et gérant, de Senneville, A.F.Gurr, assistant-comptable de Ville Mont-Royal, N.S.Verity, gérant général, de Lachine, M.Hugh Bacon, secrétaire-trésorier, de Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, J.Hanna, gérant de fabrique de chaussures, de Grand'Mère, D.J.B.Peddie, comptable des charges, de Shawinigan Falls, tous deux du district judiciaire des Trois-Rivières, André J.Dolbec, vérificateur, R.S.Langlois, Dominique Bertrand, Paul Duchaine, gérants, Paul H.Dorval, et Maurice Godbout, comptable des charges, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Promouvoir et augmenter, les connaissances, l'habileté et la compétence de ses membres, dans tout ce qui concerne la comptabilité des charges, et spécialement l'organisation des affaires et la gérance d'icelles, sous le nom de \"Cost and Management Institute\".Le montant auquel sera limité la valeur des revenus annuels que la corporation pourra posséder, sera de $5,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTLN.De Luxe Venetian Blinds Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Joseph Chateauneuf, Adelphis Lefebvre, Aristide Fraser, contractors, Louis Lafrance, grocer-butcher, Gérard Goulet, grocer-butcher, and Gérard Crête, industrialist, all of Proulxville, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To interest itself in the maintenance and repair of roads during the winter season, under the name of \"Comité des chemins d'hiver de Proulxville, Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $3,000.The head office of the corporation will be at Saint-Sévérin-de-Proubrville, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of August, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Cost and Management Institute Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of September, 1950, incorporating without share capital: J.Grundy, treasurer, of Sherbrooke, H.J.Moffatt, Secretary-treasurer, of Lennoxville, both judicial district of St.Francis, J.-B.-A.Mérineau, auditor, J.G.Mock, treasurer, Perry W.Wright, secretary-treasurer, A.V.Madge, secretary-treasurer, V.Davies, accountant, CP.Dumas, manager, all of Montreal, A.S.Keiller, general auditor, of Westmount, F.W.Naylor, accountant, of Verdun, Paul Kellogg, president & manager, of Senneville, A.F.Gurr, asst.to comptroller, of the Town of Mount-Royal, N.S.Verity, general manager, of Lachine, M.Hugh Bacon, secretary-treasurer, of-Mount-Royal, all in the Judicial district of Montreal, J.Hanna, manager, shoe factory, of Grand'Mère, D.J.B.Peddie, cost accountant, of Shawinigan Falls, both of the Judicial District of Trois-Rivières, André-J.Dolbec, auditor, R.-S.Langlois, Dominique Bertrand, Paul Duchaine, managers, Paul-H.Dorval, and Maurice Godbout, cost accountants, all of the City and Judicial District of Quebec, for the following purposes: To promote and increase the knowledge, skill and proficiency of its members in all things relating to Cost Accounting and more particularly to business organization and management, under the name of \"Cost and Management Institute\".The amount to which the value of the annual revenue derived from immoveable properties which the corporation may hold, is to be limited to $5,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.De Luxe Venetian Blinds Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec,' October 11th, 1960, Vol 82, No.11 2563 vingt-huit août 1950, constituant en corporation: Georges Charbonneau, manufacturier, Lucien Malo, commerçant, et Roland Malo, agent à commission, tous de Joliette, district judiciaire de Joliettc, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de stores vénitiens, auvents, draperies, moustiquaires métalliques, chûssis, prélarts, sous le nom de- \"De Luxe Venitian Blinds Limited\", avec un capital de S10.000 divisé en 100 actions dé 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit août 1950.L'Assistant-procureur général, 2S503-o L.DÉSILETS.day of August, 1950, incorporating: Georges Charbonneau, manufacturer, Lucien Malo, dealer and Roland Malo, commission agent, all of Joliette, judicial district of Joliette, for the following purposes: To manufacture and deal in Venetian blinds, awnings, drapes, metal screens, sashes, tarpaulin, under the name of \"De Luxe Venetian Blinds Limited\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of August, 1950.L.DÉSLLETS, 28503 Deputy Attorney General.Dominion Banana & Potato Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1950, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat, et Conseil en loi du Roi, Joseph R.Hoffman, avocat, et Jean McFarlane, doctylographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de fruits et légumes, et agir comme commerçants généraux de toutes classes de produits alimentaires, sous le nom de \"Dominion Banana & Potato Co.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 2S503 C.E.CANTIN.Duchess Potato Chips Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux août 1950, constitutant en corporation: John Brumbray, conseil en loi du Roi, de ville Mont-Royal, Jean-Paul Cardinal et Jehan Perdriau, avocat, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer aucun ou tous des commerces de manufacturiers et marchands de toutes sortes de produits alimentaires et breuvages non-alcooliques, sous le nom de \"Duchess Potato Chips Ltd.\", avec un capital de $100,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Dumais Frères Limitée Damais Brothers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie *de\" la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Dominion Banana & Potato Co.Notice is hereby given that under Part Iof the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1950, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Joseph R.Hoffman, advocate, and Jean McFarlane, typist, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of fruit and vegetable merchants and general traders in all caisses of food stuffs, under the name of \"Dominion Banana & Potato Co.\", with a capital stock of 840,000.divided into 200 acommon shares of a par value of $100.each, and 300 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1950.C.E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Duchess Potato Chips Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of August, 1950, incorporating: John Bumbray, King's Counsellor, of the Town of Mount-Royal, Jean-Paul Cardinal and Jehan Perdriau, advocates, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on any or all of the business of manufacturers of and dealers in all kinds of alimentary food products and non-intoxicating beverages, under the name of \"Duchess Potato Chips Ltd.\", with a capital stock of $100,000 divided into 500 common shares of the par value of $100.each, and 500 preferred shares of the par value of $100.each.9 The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office or the Attorney General, this twenty-second day of August, 1950.L.DÉSLLETS, 28503-o Deputy Attorney General.Dumais Frères Limitée Dumais Brothers Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 2564 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U octobre I960, Tome 82, N° Ll province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit août 1950, constituant en corporation Charles-Laurent Dumais, commerçant, de Sillery, Denis Dumais et Jean Dumais, commerçants, de la cité de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer et exploiter l'industrie et le commerce de transport et agir comme camionneurs expéditeurs, importateurs et entreposeurs; Faire le commerce et exercer l'industrie de liqueurs douces, d'eaux gazeuses et autre de même nature, de produits alimentaires; faire de toutes façons le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Dumais Frères Limitée\"\u2014\"Dumais Bothers Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit août 1950.L'Assistant-procureur général, 2S503-o L.DÉSILETS.Entreprises Verchères Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq août 1950, constituant en corporation: Hervé Forget, comptable public, de la cité de Montréal, Jean-Jacques Chagnon, surintendant, d'usine, et Alphonse Bégin, comptable public, ces deux derniers de Longueuil, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Faire tous travaux de creusage et de nivelage en général, de même que tous genres de travaux de voirie et manufacturer et faire le commerce d'appareils et matières premières nécessaires à l'exploitation du commerce de la Compagnie, sous le nom de \"Entreprises Verchères Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ver-chères, District Judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Gagnon Frbres Sales Corporation .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf août 1950, constituant en corporation: Hector Gagnon, J.-Aline Gagnon, fille majeure, tous deux industriels, et Lucien Mercier, comptable agréé, tous de Matane, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Faire en général le commerce de bois sous tou% tes ses formes, sous le nom de \"Gagnon Frères Sales Production\"; avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of August, 1950, incorporating: Charles Laurent Dumais, trader of Sillery, Denis Dumais, and Jean Dumais, traders, of the city of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on and engage in the transportation business and industry and act as truckmen, shippers, importers and warehousemen.To carry on and engage in the business of soft drinks, aerated waters, and others of the same kind, and foodstuffs; to carry on, in every way the real estate business, under the name of \"Dumais Fères Limitée\"\u2014\"Dumais Brothers Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eight day of August, 1950.L.DESILETS, 28503 Deputy Attorney General.Entreprises Verchères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of August, 1950, incorporating: Hervé Forget, public accountant, of the city of Montreal, Jean Jacques Chagnon, factory superintendent, and Alphonse Begin, public accountant, these two latter of Longueuil, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on any excavating and levelling works, in general, and also all kinds of road work and deal in the apparatus and deal in the raw materials required for the carrying on of the company's business, under the name of \"Entreprises Verchères Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Verchères, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Gagnon Frères Sales Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of August, 1950, incorporating: Hector Gagnon, J.-Aline Gagnon, spinster, both industrialists, and Lucien Mercier, chartered accountant, all of Matane, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on generally the lumber business under all the forms thereof, under the name of \"Gagnon Frères Sales Corporation\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lÂtk, 1950, Vol.82, No.11 2565 General Roofing Company Limited, General Roofing Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-rissct, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.ll.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt septembre 1950, constituant en corporation: Henriette Savoie, secrétaire, Lorenzo Cho-quette, agent, et Armand Nadeau, avocat, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de couvreurs et ferblantiers, et faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"General Roofing Company Limited\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 2S503-o C.-E.CANTIN.Gilbride Brokerage Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of September, 1950, incorporating: Henriette Savoie, secretary, Lorenzo Choquette, agent, and Armand Nadeau, advocate, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To carry on the business of roofers and tinsmiths, and to act as general contractors, under the name of \"General Roofing Company Limited\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Gilbride Brokerage Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des'compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty- du vingt-deux août 1950, constituant en cor- second day of August, 1950, incorporating: poration: Yvon Jasmin, Jean Drapeau, avocats, Yvon Jasmin, Jean Drapeau, advocates, and et Rita Dufresne, secrétaire, tous des cité et Rita Dufresne, secretary, all of the city and district judiciaire de Montréal, pour les objets judicial district of Montreal, for the following suivants: purposes: Exercer le commerce de courtiers, marchands To carry on business as brokers, dealers in de produits alimentaires, tabacs, cigares, pro- foodstuffs, tobacco, cigars, agricultural products, duits de la ferme, de toutes sortes d'animaux all sorts of domestic, aquatic or other animals, domestiques, aquatiques ou autres, sous le nom under the name of \"Gilbride Borkerage Ltd.\",.de \"Gilbride Brokerage Ltd.\", avec un capital with a capital stock of $15,000 divided into 150 dc $15,000 divisé en 150 actions de $100 cha- shares of $100 each, cunc.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le Dated at the office of the Attorney General, vingt-deux août 1950.this twenty-second day of August, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÊSDLETS, 2S503-o L.DÉSILETS.28503 Deputy Attorney General.Gosford Skeet Club Inc.Gosford Skeet Club Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions Notice is hereby given that under Part III of de la troisième partie de la Loi des compagnies the Quebec Companies' Act, letters patent have de Québec, il a été accordé par le Lieutenant- been issued by the Lieutenant-Governor of the gouverneur de la province de Québec des lettres Province of Quebec, bearing date the seventh patentes, en date du sept septembre 1950, day of September, 1950, to incorporate as a constituant en corporation sans capital-actions: corporation without share capital: Thomas Thomas Maher, ingénieur forestier, Georges Maher, forestry engineer, Georges Couture, Couture, industriel, et Robert Maher* agent industrialist, and Robert Maher, insurance d'assurances, tous des cité et district judiciaire agent, all of the city and judicial district of de Québec, pour les objets suivants: Quebec, for the following purposes: Fins sportives et sociales, sous le nom de Social activities and sports, under the name \"Gosford Skeet Club Inc.\" of \"Gosford Skeet Club Inc.\".Les pouvoirs accordés ne permettent pas les The powers conferred do not permit gambling jeux à l'argent, les jeux de hasard, les jeux de games of chance, games of chance and skill, hasard et h'abileté, les paris illégaux, et ne illegal betting, nor do they permit the corpora- permettent pas non plus à la corporation de tion to apply for, obtain or operate a license demander, obtenir ou exploiter une licence granted by the Quebec Liquor Commission, octroyée par la Commission des Liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les revenus The amount to which the annual revenue annuels des biens immobiliers que la corpo-3 from the immovable property which the cor- ration peut posséder, est de $10,000.poration may hold is to be limited, is $10,000.Le siège social de la corporation seta à Que- The head office of the corporation will be at bee, district judiciaire de Québec.Quebec, judicial district of Quebec.Daté du bureau du Procureur général le sept Dated at the office of the Attorney General, septembre 1950.this seventh day of September, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28503-o L.DÉSLLETS.28503 Deputy Attorney General. 2566 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1A octobre 1950, Tome 82, N° Al Hallet and Carey (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze septembre 1950, constituant en corporation: John Ross Tolmie, John McCreary Coyne, procureurs, du village de Rockliffe, dans la province d'Ontario, et Margaret Dorothey Daeclisel, sténographe, de la cité d'Ottawa, province d'Ontario, pour les objets suivants: Faire le commerce du grain de toutes espèces, sous le nom de \"Hallet and Carey (Quebec) Limited\", avec un capital de S 10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera L'Édifice Chambre de Commerce (Board of Trade Building) Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.H.Lapai me Transport, Ltée H.Lapalmc Cartage, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-cinq août 1950, constituant en corporation: Héliodore Laplame, Gaston \u2022 Lapalmc, Guy La-palme, Roger Lapalmc, camionneurs, et Lucille Fabien, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de transport et d'entreposage, sous le nom de \"H.Lapalme Transport Ltée\" \u2014 \" H.Lapalme Cartage, Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS- H.L.Garand & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze septembre 1950, constituant en corporation: Henri-Louis Garand, Albert Garand et Lucien Goulet, marchands, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de meubles et ameublements, sous le nom de \"H.L.Garand & Cie Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de 1$00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Hofman & S laver t Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept septembre 1950, constituant en Hal let and Carey (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1950, incorporating: John Ross Tol-mic, John McCreary Coyne, solicitors, of the Village of Rockliffe, in the Province of Ontario, and Margaret Dorothey Daechsel, stenographer, of the City of Ottawa, Province of Ontario, for the following purposes: To deal in grains of all kinds, under the name of \"Hallet and Carey (Quebec) Limited\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Board of Trade Building, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.H.Lapalme Transport, Ltée H.Lapalme Cartage, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of August, 1950, incorporating: Héliodore Lapalme, Gaston Lapalme, Guy Lapalme, Roger Lapalme, truckmen, and Lucille Fabien, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the cartage and warehousing business under the name of \"II.Lapalme Transport, Ltée\" \u2014 \"H.Lapalme Cartage, Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.H.L.Garand & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1950, incorporating: Henri-Louis Garand, Albert Garand, and Lucien Goulet, merchants, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture and sets of furniture, under the name of \"H.L.Garand & Cie Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke,-judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Hofman & Stavert Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of September, 1905, incorporating: Milton Lowen QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lÀth, 1950, Vol.82, No.il 2567 corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Irwin Bernard Blond, notaire public, et Mildred Brown, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de quincaillerie, de produits en fer, acier et métal et articles de maison; Exercer le commerce comme manufacturiers ou entrepreneurs pour la fabrication d'habits, vêtements et comme confectionneurs en général, sous le nom de \"Hofman & Stavert Incorporated\", avec un capital de $40,000 divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en $150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS, Hôpital Hôtel-Dieu de Hautcrive Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province' de Québec des lettres patentes, en date du treize septembre 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Les Révérendes Soeurs Lutgarde Allard, Pauline Maillé et Jeanne Lemire, religieuses, d\"Haute-rive district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Etablir et maintenir un hôpital, sous le nom de \"Hôpital Hôtel-Dieu de Hauterive\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $3,000,000.Le siège social de la corporation sera à Haute-rive, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général le treize septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.Klein, advocate, Irwin Bernard Blond, notary public, and Mildred Brown, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware, iron, steel, metal products, household wares; To carry on the business of manufacturers or contractors of clothing, wearing apparel and general outfitters, under the name of \"Hofman & Stavcrt Incorporated\", with a capital stock of $40,000.divided into 205 common shares of $100.each, and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.Hôpital Hôtel-Dieu de Hauterive Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies's Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: The Reverend Sisters Lutgarde Allard, Pauline Maillé and Jeanne Lemire, religious, of Haterive, judicial district of Saguenay, for the following purposes: To establish and maintain a hospital, under the name of \"Hôpital Hôtel-Dieu de Hauterive\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $3,000,000.The head office of the corporation will be at Hauterive, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Intercontinental Trading Company Limited Intercontinental Trading Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1950, constituant en corporation: Gordon Murphy Webster, procureur, de la ville de Hudson Heights, Robert Learmont, Jamieson, procureur de la ville de Pointe-Claire, Lorna Thelma Watt, fille majeure, secrétaire, de Westmount, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises faits de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et les sous-produits d'animaux et minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et périodiques, objets d'art, produits chimiques et de beauté, produits de la terre, de la mer et de la forêt, sous le nom de \"Intercontinental Trading Company Limited\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 8,000 actions sans valeur au pair ou nominale, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $40,000.Le nombre des actionnaires sera limité à vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal-, Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1950, incorporating: Gordon Murphy Webster, Barrister of the Town of Hudson Heights, Robert Learmont Jamieson, Barrister, of the Town of Pointe Claire, Lorna Thelma Watt, Spinster, Secretary, of West-mount, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise made of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass, and by-products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art, chemical and beauty products, land, sea and forest products, under the name of \"Intercontinental Trading Company Limited\".The capital stock of the company is divided into 8,000 shares having no nominal or par value, and the amount with which the company will commence its operations will be $40,000.The number of its shareholders shall be limited to twenty (20).The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General. 2568 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Il octobre 1950, Tome 82, N° 41 J.L.Legault & Sons Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf août 1950, constituant en corporation: .J.-Léonide Legault, Jacques Legault, bouchers-épiciers, de Valois, et Laurel Mauffette, comptable de Lakeside, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épiciers, boucher, mar-, chand de ferronnerie, vêtements, bois, charbon, en un mot, exercer le commerce d'un magasin général et ou départemental, sous le nom de \"J.L.Legault & Sons Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune, et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Keeno Lumber Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze septembre 1950, constituant en corporation: Claude Lagueux, comptable, Françoise Turgeon, secrétaire, tous deux de la cité de Québec, et Gertrude Turgeon, sténographe, de Lévis, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs forestiers, marchands de bois, propriétaires de scieries, et marchands généraux, sous le nom de \"Keeno Lumber Company Ltd.\", avec un capital de $5,000 divisé en 200 actions de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 126 rue St-Pierre, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.J.L.Legault & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of August, 1950, incorporating: J.-Léonide Legault, Jacques Legault, butchers, grocers, of Valois, and Laurel Mauffette, accountant of Lakeside, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as grocers, butchers, dealers in ironware, clothing, wood, coal, in a word, to carry on the business of a general and or departmental stores, under the name of \"J.E.Legault & Sons Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Keeno Lumber Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1950, incorporating: Claude Lagueux, accountant, Françoise Turgeon, secretary, both of the City of Quebec, and Gertrude Turgeon, stenographer, of Levis, all in the Judicial District of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of lumber operators, timber merchants, saw-mill proprietors and general merchants, under the name of \"Keeno Lumber Company Ltd.\", with a capital stock of $5,000 divided into 200 shares of $25 each.The head office of the company will be at 126 St.Peter St., Quebec, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Keystone Watch & Jewellery Co.Ltd.Keystone Watch & Jewellery Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the fourteenth du quatorze septembre 1950, constituant en day of September, 1950, incorporating: Benja-corporation: Benjamin Robinson, avocat et con- min Robinson, advocate and King's Counsel, of seil en loi du Roi, de Westmount, Joseph Roy Westmount, Joseph Roy Hoffman and Theodore Hoffman, et Theodore Herzl Shapiro, avocats, de Herzl Shapiro, advocates, of the City of Mont-la cité de Montréal, tous du district judiciaire de real, all in the Judicial District of Montreal, for Montréal, pour les objets suivants: the following purposes: Manufacturer et faire le commerce de toutes To manufacture and deal in all kinds of watches sortes de montres, accessoires de montres, nou- watch supplies, novelties and jewellery articles, veautés, articles de bijouterie, sous le nom de under the name of \"Keystone Watch & Jewellery \"Keystone Watch & Jewellery Co.Ltd.\", avec Co.Ltd.\", with a capital stock of $100,000.div- un capital de $100,000, divisé en 1,000 actions ided into 1,000 shares of $100.each, de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the Company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, quatorze septembre 1950.this fourteenth day of September, 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, C.E.CANTIN, 28503 .C.E.CANTLN.28503-o Acting Duputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL ÔAZETTE, Quebec, October lÂth, 1950, Vol.82, No.11 2569 Knight Stereotyping Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 27(5, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du seize septembre 1950, constituant en corporation: Nathan A.Levitsky, avocat, Rose Mar-kis, Martha Pollack, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: .Manufacturer et faire le commerce d'outillage d'imprimerie et de photographie, sous le nom de \"Knight Stereotyping Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.E.CANTIN.La Chambre de Commerce de Paspébiac The Paspébiac Board of Trade Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze septembre 1950 constituant en corporation sans capital-actions: Gérard-Déa Levesque, avocat, Léo-Albert Poirier, vendeur d'automobiles, Paul-Gérard Morin, médecin, Joseph-Michel Dubreuil, industriel, Joseph-Arthur Poirier, bijoutier, et Thomas-Caries Lcbreton, acheteur, tous de Paspébiac, district judiciaire de Bonaventure, pour les objets suivants: Founder et procureur aux résidents et aux hommes d'affaires de Paspébiac une association centrale par laquelle et avec laquelle lesdits résidents et hommes d'affaires pourront travailler effectivement aux meilleurs intérêts de la communauté et pour l'amélioration des conditions de vie qui y régnent, sous le nom de \"La Chambre de Commerce de Paspébiac\"\u2014\"The Paspébiac Board of Trade\".Le montant de la valeur de la propriété immobilière que la Corporation pourra avoir sera limité à $25,000.Le siège social de la corporation sera à Pas pébiac, district judiciaire de Bonaventure.Daté du bureau du Procureur général le douze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 2S503-o C.-E.CANTIN.La Compagnie Adolphe Lebeuf Limitée o Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec,*il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze septembre 1950, constituant en cor-ration: Adolphe Lebeuf, marchand de quincaillerie, Paul-Êmile Lebeuf et Maxime Lebeuf, commis, tous de Salaberry de Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Exercer toutes les opérations de marchands de ferronnerie, de quincaillerie, d'accessoires électriques, de meubles, et de système et appareils de chauffage, sous le nom de \"La Compagnie Adolphe Lebeuf Limitée\",avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Knight Stereotyping Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date \"the sixteenth day of September, 1950, incorporating: Nathan A.Levitsky, advocate, Rose Markis, Martha Pollack, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in printing and photography equipment, under the name of \"Knight Stereotyping Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at MontreaJ, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of September, 1950.C.E.CANTIN.28503-o Acting Deputy Attorney General.La Chambre de Commerce de Paspébiac The Paspébiac Board of Trade Notice is hereby given that under Part DII of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard Déa Levesque, advocate, Léo Albert Poirier, automobile, salesman, Paul Gérard Morin, physician, Joseph Michel Dubreuil, industrialist, Joseph Arthur Poirier, jeweller, and Thomas Charles Lei) re ton, purchaser, all of Paspébiac, judicial district of Bonaventure, for the following purposes: To provide and furnish the residents and business men of Paspébiac with a central association whereby and with which the said residents and business men may work effectively for the best interests of the community and for the improvement of the living conditions wldch prevail there, under the name of \"La Chambre de Commerce de Paspébiac\"\u2014\"The Paspébiac* Board of Trade\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Paspébiac, judicial district of Bonaventure.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.La Compagnie Adolphe Lebeuf Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1950, incorporating: Adolphe Lebeuf, hardware merchant, Paul Emile Lebeuf and Maxime Lebeuf, clerks, all of Salaberry de Valleyfield, judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To carry on the business of dealers in ironware, hardware, electrical appliances, furniture and heating systems and equipment, under the name of \"La Compagnie Adolphe Lebeuf Limitée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each. 2570 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, lk octobre I960, Tome 82, N° kl Le siège social de la compagnie sera à Sala-berry de Valleyfield, district judiciaire de Beau-harnois.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-O L.DÉSILETS.La Compagnie Canadienne d'Acoustique Limitée Canadian Acoustics Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze septembre 1950, constituant en corporation: J.-René Lessard, ingénieur professionnel, J.-Eugène Marchand, agent vendeur, et Dollard Dansereau, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"La Compagnie Canadienne d'Acoustique Limitée\" \u2014 \"Canadian Acoustics Limited\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du-bureau du Procureur général, le quatorze septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-O L.DÉSILETS.La Compagnie des Restaurants Rialto Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier septembre 1950, constituant en corporation: John Soul is, Timothéos Soul is, restaurateurs, et Michel Morisset, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'exploitation de restaurants, sous le nom de \"La Compagnie des Restaurants Rialto Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 150 actions privilégiées de $100 chacune et en 250 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2550, rue Ste-Catherine Est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-O L.DÉSILETS.Laiterie Leclerc (Sherbrooke) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du trente août 1950, constituant en corporation: Bernard Leclerc, Marc Leclerc, Marcel Leclerc, industriels, et Jean Loiselle, comptable, tous de Granby, district judiciaire de Bedford, et Auré-lien Noël, avocat, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du lait et de ses dérivés et sous-produits, sous le nom de \"Laiterie Leclerc (Sherbrooke) Ltée\", avec un capital de $100,000 divisé en 750 actions Classe \"A\" d'une valeur au pair ou nominale de $100 chacune et 250 actions Classe \"B\" d'une valeur au pair ou nominale de $100 chacune.The head office of thè company will be at Salaberry de Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.La Compagnie Canadienne d'Acoustique Limitée Canadian Acoustics Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of September, 1950, incorporating: J.René Lessard, professional engineer, J.Eugène Marchand, sales agent, and Dollard Dansereau, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in building requisites, under the name of \"La Compagnie Canadienne d'Acoustique Limitée\" \u2014 \"Canadian Acoustics Limited\", with a capital stock of $20,000 divided in 200 shares of $100 each.The head office of the corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.La Compagnie des Restaurants Rialto Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Compprues Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of September, 1950, incorporating: John Sou lis, Timothéos Soulis, restaurant keepers, and Michel Morisset, chartered accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on.the business of operating restaurants, under the name of \"La Compagnie des Restaurants Rialto Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 150 preferred shares of $100 each, and 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 2550 St.Catherine Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Laiterie Leclerc (Sherbrooke) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the vQuebec Companies Act, letters patent have beerP issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtenth day of August, 1950, incorporating: Bernard Leclerc, Marc Leclerc, Marcel Leclerc, industrialists, and Jean Loiselle, accountant, all of Granby, judicial district of Bedford, and Aurélien Noël, advocate, if the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in milk and in the derivatives and by- Èroducts thereof, under the name of \"Laiterie eclerc (Sherbrooke) Ltée\", with a capital stock of $100,000, divided into 750 Class \"A\" shares of a par or nominal value of $100 each, 250 Class \"B\" shares of a par or nominal value of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October llth, 1950, Vol.82, No.hi 2571 Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le trente août 1950.L'Assistant-procureur général, 2S503-o L.DÉSILETS.Leader Fashions Inc.A Avis est donné qu'en vertu de la premier partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par te Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf août 1950, constituant en corporation: Edward Radow, manufacturier, Doreen Milton, secrétaire, John Dimassino, surintendant, et Jyman Eric Feigelson, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce de vêtements et habits de toute description, sous le nom de \"Leader Fashions Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 < L.DÉSILETS.Le Bloc Vibré, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit septembre 1950, constituant en corporation: Joseph-Octave Paquet, manufacturier, Rosario Poulin, entrepreneur, et Orner Lussier, manufacturier, tous de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de briques et de tous matériaux de construction, sous le nom de \"Le Bloc Vibré, Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le huit septembre 1950.L'Assistnat-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Leduc et Boulanger Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit septembre 1950, constituant en corporation: J.-E.-Emile Leduc, voyageur de commerce, Joseph-Leopold Boulanger, gérant, et Philippe Saint-Jacques, comptable agréé, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire et exercer les opérations industrielles et commerciales nécessaires pour préparer, fournir et installer des systèmes de filtration pour l'eau domestique, commerciale ou industrielle et pour maintenir et entretenir ces sytèmes, sous le nom de \"Leduc et Boulanger Ltée\", avec un capital de $49,900 divisé en 499 actions de $100 chacune.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Leader Fashions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of August, 1950, incorporating : Edward Radow, manufacturer, Doreen Milton, secretary, John Dimassino, superintendant, and 'Jyman Eric Feigelson, advocate, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in garments and clothing of every description, under the name of \"Leader Fashions Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares at $10.each, and 300 preferred shares at $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day.of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.Le Bloc Vibré, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1950, incorporating: Joseph-Octave Paquet, manufacturer, Rosario Poulin, contractor and Omer Lussier, manufacturer, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes; To manufacture and deal in bricks and all other materials, under the name of \"Le Bloc Vibré, Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 ' Deputy Attorney General.Leduc et Boulanger Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1950, incorporating: J.E.Emile Leduc, commercial traveller, Joseph Leopold Boulanger, manager, and Philippe Saint-Jacques, chartered accountant, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To carry on and engage the industrial and commercial operations required to prepare, furnish and install water filtration systems for domestic, commercial or industrial purposes and to maintain and service the said systems, under the name of \"Leduc et' Boulanger Ltée\", with a capital stock of $49,900 divided into 499 shares of $100 each.The number of shareholders of the company will be limited to twenty.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis. 2572 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, IL octobre 1950, Tome 82, N° Ll Daté du bureau du Procureur général le huit Dated at the office of the Attorney General' septembre\" 1950.this eighth day of September, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28503-o L.DÉSILETS.28503 Deputy Attorney General.Les Entreprises St-Jacqucs Inc.Les Entreprises St-Jacqucs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the seventh du sept septembre 1950, constituant en corpo- day of September, 1950, incorporating: Gisèle ration: Gisèle Mercier, sténographe, Jean lia- Mercier, stenographer, Jean Racicot, notary, cicot, notaire, tous deux de la cité de Montréal, both of the City of Montreal, and Marc Leroux, et Marc Leroux, notaire, de Ville Mont-Royal, notary, of the town of Mount Royal, all of .the tous du district judiciaire de Montréal, pour les judicial district of Montreal, for the following objets suivants: purposes: Exercer le commerce et l'industrie de biens To carry on the real estate business and in- immeubles sous toutes ses formes, sous le nom dustry, under all the forms thereof, under the de \"Les Entreprises St-Jacqucs Inc.\", avec un name of \"Les Entreprises St-Jacques Inc.\", capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 with a capital stock of $40,000, divided into 400 chacune.shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire fie Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le sept Dated at the office of the Attorney General, septembre 1950.this seventh day of September, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28503-o L.DÉSILETS.28503 Deputy Attorney General.L'Hôtel Matane, I.tee Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été \"accordé par le Lieutcnant-gduverneur de la province de Québec des lettres patentes en date, du six septembre 1950, constituant en corporation: AH)crt Gagnon, hôtelier, de Matane, district judiciaire de Rimouski, Gérard Latouchc, commis, de Beauport-Est, Françoise Bédard, sténographe, François Lemieiix, courtier, tous deux de Québec, et André Let arte, courtier de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'hôteliers sous le nom de \"L'Hôtel Matane, Ltée\", avec un capital de $100,000 divisé en 750 actions ordinaires de $100 chacune, et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compgnie sera à Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le six septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.-E.CANTIN.L'Hôtel Matane, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Prvince of Quebec, bearing date the sixth day of September, 1950, incorporating: Albert Gagnon, hotel keeper, of Matane, judicial district of Rimouski, Gérard Latouche, clerk, of Beauport-Est, Françoise Bédard, stenographer, François Lemieux, broker, both of Quebec, and Andre I^etarte, broker, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the trade and business of hotel keepers, under the name of \"L'Hôtel Matane, Ltée\", with a capital stock of $100,000 divided into 750 common shares of $100 each and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.L.O.Laporte Limitée Avis est donné qu'en vertu de la premirèc partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze septembre 1950, constituant en corporation: Samuel David Rucenko, avocat et conseil en loi du Roi, Clarence Reuben Gross, avocat, Meta Henry, secrétaire, tous de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce de manufacturier et commerçant de matériaux de construction et agir comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"L.O.Laportc Limitée\", avec un capital de 8100,000 divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.L.O.Laportc Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'^Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 27G R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of September 1950, incorporating: Samuel David Rudcnko, Advocate and King's Counsel, Clarence-Reuben Gross, Advocate, Meta Henry, Secretary, all of Montreal, judicial district ofi Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of manufacturing and dealing in building materisals and to act as general contractors and builders, under the name of \"L.O.Laporte Limitée\", with a capital stock of $100,000.divided into 500 common shares of $100.each and 500 preferred shares of $100.each. QUEBEC OFFICIAL QAËETTË, Quebec, October llth, I960, Vol 82, No.L2 2573 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.E.CANTIN.Longcroft Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred, Morissct, conformément à l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du seize septembre 1950, constituant en corporation: Harold Lande, Joesph S.Caplan et Murray Lapin, avocats, tous des cité et district judiciaires de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce» de machinerie, appareils et outillage de toutes sortes, produits chimiques, cosmétiques, parfums et tous autres produits similaires ou connexes.s ous le nom de \"Longcroft Ltd.\", avec un capital de §40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 ' C.E.CANTIN.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September; 1950.C.E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.' Longcroft Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixteenth day of September, 1950, incorporating: Harold Lande, Joseph S.Caplan and Murray Lapin, advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in machinery.applian-ces, equipment of all kinds, chemicals, cosmetics, perfumes, and any other allied or similar products, under the name of \"Longcroft Ltd\", with a.capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares having a par value of $1.each, and 390 preferred shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of September, 1950.C.E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Lumber Products Manufacturing Export Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente août 1950, constituant en corporation: Joseph Lavoie, Michœl Aylwin, Moore Riley, vendeurs, Edward Frederick Malkin, administrateur d'affaires, et Faye Stephenson, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous genres de machines, outils, outillage, solutions et procédés, toutes sortes de produits de bois, métaux ou plastique, biens mobiliers, meubles, garnitures et accessoires, sous le nom de \"Lumber Products Manufacturing & Export Ltd.\".Le capital de la compagnie est divisé en 480 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 400 actions sans valeur nominale ou au pairet le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations ne sera pas moins que $6,800.^ - Le nombre des actionnaires sera restreint à pas plus que vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à 437 ouest rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Magasin du Sport Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt septembre 1950, constituant en corporation: J.-Arthur Tremblay, Georges-S.Tremblay, Lumber Products Manufacturing & Export Ltd.Notice is hereby given that under Parti of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, incorporating: Joseph Lavoie, Michœl Aylwin, Moore Ryley, salesmen, Edward Frederick Malkin, business executive, and Faye Stephenson, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes : To manufacture and deal in all types of machines, tools, equipment, solutions and processes, all kinds of wood, metal or plastic products, movables, furniture, trimmings and accessories, under the name of \"Lumber Products Manu-turing & Export Ltd.\".The capital stock of the company is divided into 480 preferred shares of the par value of $100 each, and into 400 shares having no nominal or par value and the amount with which the company will commence its operations will not be less than $6,800.The number of shareholders shall be restricted to not more than twenty (20).The head office of the company will be at 437 St.James street West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tliis thirtieth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.Magasin du Sport Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of September, 1950, incorporating: J.Arthur Tremblay, Georges S.Tremblay, Ls.Charles Ga- 2574 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, lk octobre 1950, Tome 82, N° kl Ls-Charles Gagnon, marchands de Jonquière, et Adélard Jean, marchand, de Kénogami, tous du district judiciaire de Chicoutimî, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles de fumeurs, d'articles en cuir, de bijouterie, d'instruments de musique, de quincaillerie et ferronnerie, de matériaux de construction, de meubles et de jouets, sous le nom de \"Magasin du Sport Limitée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Lé siège social de la compagnie sera à 38, rue Cabot, Kénogami, district judiciaire de Chicqu-timi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.gnon, merchants, of Jonquières, and Adélard Jean, merchant, of Kénogami, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in smokers' supplies, sporting goods, leather articles, jewellery, musical instruments, hardware and ironware, building materials, furniture and toys, under the name of \"Magasin du Sport Limitée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares ôf $100 each.The head office of the company will be at 38 Cabot street, Kenogami, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Maraîchers Unis Ltée United Market-Gardeners Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, H a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt septembre 1950, constituant en corporation: Yvon Jasmin, Réal Marcoux, avocats, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secrétaire, tous de Montréal, J.-Roger Marceau, commis de St-Mathias, district judiciaire de St-Hya-cinthe, pour les objets suivants: Exercer sous toutes ses formes le commerce de fruits, légumes, produits alimentaires, produits de la ferme, instrument et machines \"aratoires, sous le nom de \"Maraîchers Unis Ltée\"\u2014 \"United Market-Gardeners Ltd.\", avec un capital de $500,000.divisé en 6,000 actions orr dinaires de $10.chacune, et 4,400 actions privilégiées de $100.chacune.Le siège social de la compagnie sera à l'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o .C.-E.CANTIN.Maraîchers Unis Ltée United Market-Gardeners Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of September, 1950, incorporating: Yvon Jasmin, Real Marcoux, advocates, Lucienne Merineau, Rita Dufresne, secretaries, all of Montreal, J.Roger Marceau, clerk of St-Mathias, judicial district of St-Hyacinthe, for the following purposes: To deal in all lines of fruits, vegetables, foodstuffs, farm products, farm implements and machinery under the name of \"Maraîchers Unis Ltée\"\u2014\"United Market-Gardeners Ltd.\", with a capital stock of $500,000 divided into 6,000 common shares of $10 each, and 4,400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at L'Abord-à-Plouffe, judicial district of -Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Maurice L'Abbé Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente août 1950, constituant en corporation: Charles-Edouard Bertrand, avocat, Marthe Toupin, secrétaire, et Jean-Paul Dansereau, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs-plâtriers et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Maurice L'Abbé Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Maurice L'Abbé Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, incorporating: Charles-Edouard Bertrand, adveate, Marthe Toupin, secretary, and Jean Paul Dansereau, avocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as plastering-contractors and as general contractors, under the name of \"Maurice L'Abbé Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.McLean Press Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1950, constituant en corpo- McLcan Press Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1950, incorporating: Robert W. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October liih, 1950, Vol.82, No.LI 2575 ration: Robert W.McLean, David, A.McLean, John McLean, James McLean, administrateurs, Malcolm H.Blakely, comptable agréé et A.H.Graham Gould, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets* suivants: Exercer le commerce d'imprimerie en général, sous le nom de \"McLean Press Limited\", avec un capital de §20,000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le nombre des actionnaires de la compagnie est limité à vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à 1030 rue St-Alexandre, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DESILETS.Meunier Refrigeration Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit août 1950, constituant en corporation: Rémi Meunier, mécanicien en regrigéra-tion, Armand Meunier, mécanicien en réfrigération, tous deux de Montréal, et Lucille Chaussé, employée civile, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer la fabrication, le commerce d'appareils et accessoires pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation, la climatisation et l'air conditionné, quincaillerie, meuble, accessoires électriques en général, sous le nom de \"Meunier Réfrigération Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en \u2022100 actions de- $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Modem Clothing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du seize septembre 1950, constituant en corporation: Nathan A.Levitsky, avocat, Rose Markis et Martha Pollack, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de drap, vêtements, plastiques ou tous autres étoffes et machineries employés dans la production de vêtements et accessoires vestimentaires, sous le nom de \"Modem Clothing Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le seize septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.Morisette & Frères Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été McLean, David A.McLean, John McLean, James McLean, executives, Malcolm H.Blakely, chartered accountant,.and A.H.Graham Gould, advocate, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general printing, under the name of \"McLean Press Limited\", with a capital stock of $20,000.divided into 2,000 common shares of $10.each.The number of shareholders of the company is limited to twenty (20).The head office of the Company will be at 1030 St.Alexander Street, Montreal, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-O Deputy Attorney General.Meunier Refrigeration Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of August, 1950, incorporating: Rémi Meunier, regrigeration mechanic, Armand Meunier, refrigeration mechanic, both of Montreal, and Lucille Chaussée civil servant, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in apparatus and accessories for heating, refrigeration, ventilation and air-conditioning, harware, furniture, electrical accessories in general, under the name of \"Meunier Refrigeration Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.\u2022 The head office of the company, will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Modern Clothing Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.A.Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941,' bearing date the .sixteenth day of September 1950, incorporating: Nathan A.Levitsky, advocate, Rose Markis and Martha Pollack, secretaries, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in cloth, clothing, plastics or any other materials and machinery used in the production of wearing apparel and accessories, under the name of \"Modern Clothing Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 50 common shares of a par value of $100 each, and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Morisette & Frères Ltée ¦ Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been 2576 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Il octobre 1950, Tome 82, N° Il accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en .date du quatre août 1950, t constituant en corporation: Rosario Morissette, Armand Morissctte, industriels, de Laurierville, et Paul Gagné, industriel, de Ste-Julie, tous du district judiciaire d'Artha-baska, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce et l'industrie de meubles; exploiter des limites à bois, chantiers, scieries, ateliers de menuiserie; faire le commerce du bois et des matériaux de construction; exploiter des fonderies, ateliers de mécanique; Exercer le commerce de voiturier public et camionneur; acquérir .posséder, exploiter des entrepôts privés et publics, sous le nom de \"Morissette & Frère Ltée\", avec un capital de $100,000 divisé en 500 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune, et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laurier-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le quatre août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of August, 1950, incorporating: Rosario Morissette, Armand Morissette, industralists, of Laurierville, and Paul Gagné, industrialist, of Ste-Julie, all of the judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on the furniture trade and business in general; operate timber limits, lumber camps, saw-mills, carpentry shops; to deal in lumber and building requisities; operate foundries and machine shops; To carry on the business of public carrier and carter; to acquire, own and operate private and public warehouses, under the name of \"Morissette & Frère Ltée\", with a capital stock of $100,000 divided into 500 common shares of a par value of $100 each, and 500 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Laurierville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.National Carton Specialties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du onze septembre 1950, constituant en corporation: Charles Brownstcin, Melvin Salmon, avocats, Mary Steiman, Betty Pomerantz, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de papier, corde, planche, pulpe, pulpe de bois et aucune et toutes sortes de produits chimiques, les ingrédients, produits, sous-produits et composés d'iceux, sous le nom de \"National Carton Specialties Ltd.\" avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.National Cooperage,.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de-Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize septembre 1950, constituant en corporation: Arthur Nathaniel Paxton, Arthur James Paxton, de Westmount, Frank Bazso, Jr., de Rosemont, tous manufacturiers, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Faire le commerce Comme tonneliers et exercer le commerce de la tonnellerie sous toutes ses formes, sous le nom de \"National Cooperage, Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune; Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le treize septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 ' C.-E.CANTIN.National Carton Specialties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September 1950, incorporating: Charles Brownstein, Melvin Salmon, advocates, Mary Steiman, Betty Pomerantz, Secretaries, filles majeures, all of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in any and all kinds of paper, twine, board, pulp, wood pulp and any and all chemicals, ingredients, products, by products, and compounds thereof, under the name of \"National Carton Sepcialties Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 100 common shares of the parvalue of $10.each and 3,900 preferred shares of the par value of $10.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.- Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.National Cooperage, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September, 1950, incorporating: Arthur Nathaniel Paxton, Arthur James Paxton, of Westmount, Frank Bazso Jr., of Rosemont, all Manufacturers, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as coopers and the general business of cooperage in all its branches, under the name of \"National Cooperage, Ltd.\", with a, capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100, each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 25803-O Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lAth, 1950, Vol 82, No.11 2577 National Knitting Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq septembre 1950, constituant en corporation: Gordon Murphy Webster, procureur, de la ville de Hudson Heights, Robert Learmont Jatnieson, procureur, de la ville de Pointe Claire et Lorna ïhelma Watt, secrétaire, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles tricotés, d'articles vestimentaires et marchandises en drap tissés ou autrement manufacturés, fils de soie, laine, coton ou autres étoffes, sous le nom de \"National Knitting Co.Ltd.\", avec un capital de S40,000 divisé en 40,000 actions de SI chacune.Le nombre de ses actionnaires sera limité à vingt (20).t Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.N.E.Deniers & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze septembre 1950, constituant en corporation: Nazaire-E.Demers, commerçant, Dame Marie-Louise Côté Demers, ménagera, épouse contractuellement séparée de biens du Nazaire-E.Demers, et Jean-Paul Daigle, commis, tous trois de la paroisse de Saint-Agapit, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Commerce de bois en général et d'engrais alimentaires, sous le nom de \"N.E.Demers & Fils Ltée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Agapit-Station, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-o C.E.CANTIN.National Knitting Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have I >ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of September, 1950, incorporating: Gordon Murphy Webster, barrister, of the Town of Hudson Heights, Robert Learmont Jamieson, barrister, of the Town of Pointe Claire, and Lorna The 1 ma Watt, secretary, of Westmount, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitted goods, woven or otherwise manufactured articles of clothing and cloth goods, yearns of silk, wool, cotton or other materials under the name of \"National Knitting Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 40,000 shares of $1.each.The number of its shareholders shall be limited to twenty (20).The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.N.E.Demers & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have \u2022been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of September, 1950, incorporating: Nazaire E.Demers, tradesman, Dame Marie Louise Côté Dcrmers, housewife, wife separate as to property by marriage contract of Nazaire E.Demers, and Jean Paul Daigle, clerk, all three of the parish of Saint-Agapit, judicial district of Quebec, for the following purposes: The lumber trade in .general and deal in cattle feed, under the name of \"N.E.Demers & Fils Ltée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint-Agapit-Station, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of September, 1950.C.E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Ostiguy Automobile Ltée Ostiguy Automobile Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente août 1950, constituant en corporation: Arthur Dansereau, avocat, de Mont-Royal, Maurice Riel, avocat, de Laprairie, tous deux du district judiciaire de Montréal, et Gabriel Marchand, avocat, d'Iberville, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: Faire l'exploitation de garages et le commerce de véhicules-automobiles, sous le nom de \"Ostiguy Automobile Ltée\" \u2014 Ostiguy Automobile Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Richelieu, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le trente août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS./ Ostiguy Automobile Ltée Ostiguy Automobile Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, incorporating: Arthur Dansereau, advocate, of Mount Royal, Maurice Riel, advocate, of Laprairie, both of the judicial district of Montreal, and Gabriel Marchand, advocate, of Iberville, judicial district of Iberville, for the following purposes: To operate garages and deal in motor vehicles, under the name of \"Ostiguy Automobile Ltée\" \u2014 \"Ostiguy Automobile Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Richelieu, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of August, 1950.L.DÉSLLETS, 28503 Deputy Attorney General. 2578 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1A octobre 1960, Tome 82, N° Al Page & Lalondc Auto Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1950, constituant en corporation: Charles-Edouard Bertrand, avocat, Alphonse Bégin, et Hervé Forget, comptables agréés, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Opérer un commerce de garage, de voitures-automobiles et autres véhicules, sous le nom de \"Page & Lalonde Auto Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rigaud, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.Page & Lalonde Auto Inc.Notice is hereby.given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1950, incorporating : Charles Edouard Bertrand, advocate, Alphonse Begin and Hervé Forget, chartered accountants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a garage business, deal in automobiles and other vehicles, under the name of \"Page & Lalonde Auto Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each, and 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Rigaud, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Paul A.Schultz & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre juillet 1950, constituant en corporation: Ross Arthur Cecil Henry, Wallace Ross Henry, avocats et Anne Smyth, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux et constructeurs et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Paul A.Schultz & Co.Ltd.\", avec, un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre juillet 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Paul A.Schultz & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by th\"e Lieutenant-Governor of the -Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of July, 1950, incorporating: Ross Arthur Cecil Henry, Wallace Ross Henry, advocates, and Anne Smyth, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, and lo deal in building materials, under the name of \"Paul A.Schultz & Co.Ltd.\", with a capital stock of $25,000.divided into 250 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fourth day of July, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.Progress Ribbon Mills Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze septembre 1950, constituant en corporation: Gordon Murphy Webster, procureur, de la ville de Hudson Heights, Robert Learmont Jamieson, procureur, de la ville de Pointe Claire et LornaThelma Watt, secrétaire, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et autrement faire le négoce et le commerce de textiles, soieries, rayons, coton, laine, articles synthétiques, filés, fils, rubans dentelles,, draps, sous le nom de \"Progress Ribbon Mills Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le nombre de ses actionnaires sera limité à vingt (20).Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 - L.DÉSLLETS.Progress Ribbon Mills Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1950, incorporating: Gordon Murphy Webster,1 barrister, of the Town of Hudson Heights, Robert Learmont Jamieson, barrister, of the Town of Pointe Claire, and Lorna Thelma Watt, secretary, of the City of Westmount, all in the Judicial district of Mont-treal, for the following purposes: To manufacture and otherwise deal in and with textiles, silks, rayons, cottons, wools, synthetics, yarns, threads, ribbons, laces, cloths, under the name of \"Progress Ribbon Mills Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 40,000 shares of $1.each.# / The number of its shareholders shall be limited to twenty (20)., * The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of .September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lkth, 1950, Vol.82, No.11 2579 Samark Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux mai 1950, constituant en corporation: William Labow, pharmacien, Mabel Maislin Labow, ménagère, épouse séparée de biens dudit William Labow et Jack London, pharmacien, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de gestion et d'amélioration d'immeubles et biens fonds et celles d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Samark Realty Corporation\", avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.m _ Selkirk Metal Products CQuebec) Limited Avis est donnéqu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente août 1950, constituant en corporation: Henry Gordon Harvey Smith, Edward John Kirby, Gordon Campbell Chown, avocats, Leifur Julius Hallgrimson, étudiant en droit, Florence Bancroft Walker, Mildred Ellen Tovell, secrétaires, tous de la cité de Winnipeg, dans la province de Manitoba, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et commerçants de métaux et de produits de métaux, sous le nom de \"Selkirk Metal Products (Quebec) Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 8,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente août 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.Si ta \u2014 Adventure Trails Ltd.¦ Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1950, constituant en corporation: Clarence Francis McCaffrey, avocat et conseil en loi du Roi, James Pettigreu Diplock, avocat et procureur, et Mildred Agnes Calla-ghan, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Organiser et conduire des voyages; fournir des guides et aussi un service personel à ses patrons, et conduire, pour les voyageurs, ainsi que pour les expéditeurs et autres, des bureaux d'information, sous le nom de \"Sita\u2014Adventure Trails Ltd.\".Le capital actions de la compagnie est divisé en 200 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant de capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $1,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.E.CANTIN.Samark Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1950, incorporating: William Labow, pharmacist, Mabel Maislin Labow, housewife, wife separate as to property of the said William Labow, and Jack London, pharmacist, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a real estate and immoveable management, improvement and investment company, under the name of \"Samark Realty Corporation\", with a capital stock of $75,000 divided into 750 shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28503-O Deputy Attorney General.Selkirk Metal Products (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, incorporating: Henry Gordon Harvey Smith, Edward John Kirby, Gordon Campbell Chown, barristers-at-law, Leifur Julius Hallgrimson, student-at-law, Florence Bancroft Walker, Mildred Ellen Tovell, secretaries, all of the City of Winnipeg, in the Province of Manitoba, for the following purposes: To carry on the business of manufacturer of and dealers in metals and metal products, under the name of \"Selkirk metal products (Quebec) Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 8,000 shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office, of the Attorney General, this thirtieth day of August, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-O Acting Deputy Attorney General.Sita \u2014 Adventure Trails Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of September, 1950, incorporating: Clarence Francis McCaffrey, barrister and King's Counsel, James Pettigreu Diplock, barrister and solicitor, and Mildred Agnes Callaghan, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To organize and conduct tours; to furnish guides and personal attendance to its patrons, and to conduct information bureaus for travelers, shippers and others, under the name of \"Sita\u2014 Adventure Trails Ltd.\", The capital stock of the Company is divided into 200 shares having no nominal or par value and the amount of capital with which the company will commence its operations will be $1,000.The head office of^the^Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General; this eighth day of September, 1950.m C.E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy^Attorney General. 2580 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, U octobre 1950, Tome 82, N° 1>1 Slatex Import & Export Co.Slatex Import & Export Co.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the fourteenth du quatorze septembre 1950, constituant en day of September, 1950, incorporating: Philip corporation: Philip Fischel Vincberg, David Fischel Vineberg, David Goodman, advocates, Goodman, avocats et Yvonne Bélanger, secré- and Yvonne Bélanger, secretary, all of the City taire, tous des cité et district judiciaire de and Judicial District of Montreal, for the follow-Montréal, pour les objets suivants: ing purposes: Manufacturer et faire le commerce général de To manufacture and deal generally in textiles, textiles, tissus textiles, fournitures de maison, textiles fabrics, house furnishings, clothing and habits et vêtements, sous le nom de \"Slatex wearing apparel, under the name of \"Slatex Import & Export Co.\", avec un capital de Import & Export CO.\", with a capital stock $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune, of $40,000.divised into 4,000 shares of $10.each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the Company will be at real, district judiciaire de Montréal.* Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, quatorze septembre 1950.this fourteenth day of September, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28503 L.DÉSILETS.28503-o Deputy Attorney General.- -' *\u2022 SIeepex Limitée Slecpcx Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize septembre 1950, constituant en corporation: Giulio Romano, industriel, arthur Romano, musicien, Jean Romano, commis, Maria Romano, commis-vendeur, et Jeanne Girard, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Fabriquer, manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de remèdes et médicaments brevetés ou patentés, sous le nom de \"SIeepex Limitée\"\u2014\"SIeepex Limited\", avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de-la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503-o L.DÉSILETS.SIeepex Limitée SIeepex Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been .issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of September, 1950, incorporating: Giulio Romano, industrialist, Arthur Romano, musician, Jean Romano, clerk, Mario Romano salesman, and Jeanne Girard, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, fop»the following purposes: To make, manufacture and deal in all kinds of patented remedies and médecines, under the name of \"SIeepex Limited\"\u2014\"SIeepex Limited\", with a capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503 Deputy Attorney General.Specialty Leather Products Inc.Avis est donné qu'en vertu 'de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente août 1950, constituant en corporation: Daniel Silver, manufacturier, Saul Cyril Rynd, comptable, tous deux de la cité de Montréal, Max Coblentz et Sam Royce Altrows, avocats, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et autrement faire le traffic ou le commerce de la chenille, le cuir, le coton, les lainages, les soies, les toiles, le jute, et les hardes et vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Specialty Leather Products Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 2,000 actions privilégiées, de $10 chacune, et 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur Général, le trente août 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Specialty Leather Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of August, 1950, incorporating: Daniel Silver, manufacturer, Saul .Cyril Rynd, accountant, both of the City of Montreal, Max Coblentz and Sam Royce, Altrows, adovcates, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and otherwise deal in or with chenille, leather, cottons, woollens, silks, linens, jute and clothing and wearing apparel of every sort, under the name of \"Specialty Leather Products, Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 2,000 preferred shares of $10.each, and 2,000 common shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of August, 1950.s L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lAth, 1960, Vol.82, No.11 2581 St.Denis Outfitters Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier septembre 1950, constituant en corporation: Nathan Dinovitzer, Norman J.Samuels, marchands et Sam Samuels, opérateur en vêtements, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et négociants de marchandises sèches, vêtements, meubles, bijouterie, articles de sport et accessoires de maison, sous le nom de \"St.Denis Outfitters Inc.\", avec un capital de 839,000 divisé en 390 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Texas Tavern Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dde Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier septembre 1950, constituant en corporation: Mireille Schmidt, opératrice de téléphone, Thérèse G raton et Irène Leduc, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtel, taverne, auberge, et'ou restaurant, ou toute 'combinaison d'iceux, sous le nom de \"Texas Tavern Limited\", avec un capital de $30,000, divisé en 300 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 \u2022 L.DÉSILETS.The Canadian Mcrritt Chain Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze septembre 1950, constituant en corporation: Samuel E.Sehwisberg, Cyril E.Sehwisberg, d'Outremont, et Samuel Green-blatt, de Montréal, tous avocats, du district judiciaire de Monréal, pour les objets suivants: Manufacturer, trafiquer, et, de toutes manières, faire le commerce des métaux, minéraux et plastiques, sous le nom de \"The Canadian Merritt Chain Ltd.\", avec un capital de S100,000, divisé en 100,000 action de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 2S503 C.-E.CANTIN.The Têtreaultville Women's Club Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-fouverneur de la province de Québec^des lettres patentes en date du quatorze juin 1950, constituant en corporation sans capital actions: St.Denis Outfitters Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of September, 1950, incorporating: Nathan Dinovitzer, Norman J.Samuels, merchants, and Sam Samuels, clothing operator, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as merchants and dealers in dry goods, wearing apparel, furniture, jewellery sporting goods and household appliances, under the name of \"St.Denis Outfitters Inc.\", with a capital stock of $39,000.divided into 390 shares of 8100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this firs day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney Genera.l Texas Tavern Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of September, 1950, incorporating: Mireille Schmidt, telephone-operator, Thérèse Graton and Irène Leduc, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel, tavern, public house and'or restaurant or any combination thereof, under the name of \"Texas Tavern Limited\", with a capital stock of $30,000; divided into 300 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Ville St.Lawrence, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.The Canadian Merritt Chain Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of September, 1950, incorporating: Samuel E.Sehwisberg, Cyril E.Sehwisberg, of Outre-mont, and Samuel Greenblatt, of Montreal, all advocates, of the Judicial District of Montreal, for the following purposes: .* .To manufacture and deal in and with all manner of metals, minerals and plastics, under the name of \"The Canadian Merritt Chain Ltd.\", with a capital stock of $100,000.divided into 100,000 shares of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.The Tétreaultville Women's Club Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1950, incorporating without share capital: Jean Lyons, 2582 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, li octobre 1950, Tome 82, N° il Jean Lyons, épouse commune en biens de Elmer Lyons et dûment autorisée par lui, Adelaide Richard, épouse séparée de biens de Louis Richard, et dûment autorisée par lui, Jean Turner, épouse commune en biens de Leslie Turner, et dûment autorisée par lui, et Ethel White, épouse séparée de biens de-James White et dûment autorisée par lui toutes quatre des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Former un centre de réunion où les femmes peuvent se rencontrer dans un but d'aide mutuelle, amélioration sociale et détente, sous le nom de The \"Tétreaultvillc Women's Club\".Les pouvoirs de la corporation ne permettent pas les jeux à l'argent, les jeux de hasard ou les jeux mixtes de hasard et d'habileté; Les pouvoirs de la corporation ne l'autorisent pas non plus à demander, Retenir ou opérer une licence octroyée par la Commission des Liqueurs de Québec; Le montant auquel sera limité la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder sera $50,000.Le siège social de la corporation sera à Té-treaultville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Tie City Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du douze septembre 1950, constituant en corporation: Philip Meyerovitch, c.r., Louis Feigenbaum, Hyman Solomon, avocats, et Morris Shuter, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtement, hardes, et accessoires vestimentaires de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Tie City Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.-E.CANTIN.Trans-Canada Bedding Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro-' vince de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze septembre 1950, constituant en corporation: René Trudel, René Bruneau et Gordon Champagne, rembourreurs, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de meubles, sous le nom de \"Trans-Canada Bedding Incorporated\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5117, 7ième Avenue, Rosemont, district judiciaire de Montréal.wife common as to property of Elmer Lyons and duly authorized by him Adelaide Richard, wife separate as to property of Louis Richard and duly authorized by him, and Ethel White, wife separate as to property of James White, and duly authorized by him, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: .To form a community centre where women may meet for mutual help, improvement and social relaxation, under the name of \"The Tetreaultville Women's Club\".The powers of the corporation do not permit gambling games, games of chance or games of chance and skill mixed; The powers of the corporation do not authorize the corporation to ask, hold or operate any license granted by the Quebec Liquor Commission; The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $50,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Tetreaultville, in the Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.Tie City Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1950, incorporating: Philip Meyerovitch, K.C., Louis Feigenbaum, Hyman Solomon, advocates, and Morris Shuter, accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing, wearing apparel and furnishings of every kind and description, under the name of \"Tie City Inc.\", with a capital stock of .$40,000 divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each, and 300 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Trans-Canada Bedding Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of September, 1950, incorporating: René Trudel-René Bruneau and Gordon Champagne, upholsterers, all of the city and judicial district of Mont, real, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, under the name of \"Trans-Canada Bedding Incorporated\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 5117, 7th Avenue, Rosemount, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lLth, 1950, Vol 82, No.11 2583 Daté du bureau du Procureur général le quatorze septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503-O C.-E.CANTIN.Two-Way Car Wash Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit septembre 1950, constituant en corporation: David Goodman, Jack Lightstone, avocats, Frances Walters, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Gérer et opérer des garages et faire le commerce d'automobiles, sous le nom de \"Two-Way Car Wash Limited\", avec un capital de §75,000 divisé en'5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, ¦ 28503 C.E.CANTIN.Val Royal Building Materials Ltd.Matériaux de Construction Val Royal Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du sept septembre 1950, constituant en corporation: John Bumbray, conseil en loi du Roi, de Ville Mont-Royal, Lovell Coverhill Carroll, conseil en loi du Roi, Jean-Paul Cardinal, Jehan IVrdriau, avocats, et Françoise Caisse, secrétaire, tous quatre de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces, métiers et activités de manufacturiers généraux et négociants d'aucune et toutes sortes de matériaux et accessories de construction et de bâtiment, sous le nom de \"Val Royal Building Materials Ltd,\" \u2014 \"Matériaux de Construction Val Royal Ltée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune, et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept septembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 28503 C.E.CANTIN.Virball Electric Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six septembre 1950, constituant en corporation : Stanley Virball, Théodore Joseph Navickas, électriciens, et Alexander I.Popliger, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme électriciens, manufacturiers et marchands d'appareils et accessoires électriques de toute description, sujet aux dispositions dé la loi concernant les électriciens et les installations électriques, sous Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of September, 1950.C.-E.CANTIN, 28503 Acting Deputy Attorney General.Two-Way Car Wash Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing, date the eighth day of September, 1950» incorporating: David Goodman, Jack Lightstone, Advocates, Frances Walters, Secretary, Fille Majeure, all of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manage and operate garages and deal in and with motor cars, under the name of \"Tow-Way Car Wash Limited\", with a capital stock of $75,000 divided into 5,000 preferred shares of the par value of $10.each and 2, 500 common shares of par value of $10.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of September 1950.C.E.CANTIN, 28503-o Acting Deputy Attorney General.Val Royal Building Materials Ltd.Matériaux de Construction Val Royal Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of September, 1950, incorporating: John Bumbray, King's Counsellor, of the Town of Mount-Royal, Lovell Caverhill Carroll, King's Counsellor, Jean-Paul Cardinal, Jehan Perdriau, advocates, and Françoise Caisse, secretary, all four of the City of Montreal, all in the Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses, trades and activities of general manufacturers and dealers in and with any and all kinds and descriptions of building and construction materials and supplies, under the name of \"Val Royal Building Materials Ltd.\" \u2014 \"Matériaux de Construction Val Royal Ltée\",.with a capital stock of $20,000.divided into 200 common shares having a par value of $5.each, and 190 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of September ,1950.C.E.CANTIN, 28503-O Acting Deputy Attorney General.Virball Electric Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of September, 1950, incorporating: Stanley Virball, Théodore Joseph Navickas, electricians, and Alexander I.Popliger, advocate, all of- the Ciiy and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of electricians, manufacturers and dealers in electric appliances and accessories of every description, subject to the provisions of the Electricians and Electrical Installations Act, under the name of \"Virball 2584 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, IL octobre 1950, Tome 82, N° il le nom de \"Virball Electric Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Wilbank Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date, du six septembre 1950, constituant en corporation: Lovell Caverhill Carroll, conseil en loi du Roi, Françoise Caisse, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, et John Bumbray, conseil en loi du Roi, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger le commerce et opérer une agence de placement et de courtage en général, sous le nom de \"Wilbank Investments Ltd.\" avec un capital de $50,000 divisé en 50,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.Electric Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 4,000 shares of $1Q each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.Wilbank Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of September, 1950, incorporating: Lovell Caverhill Carroll, King's Counsel, Françoise Caisse, secretary, both of the City of Montreal, ami John Bumbray, King's Counsel, of the Town of Mount Royal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To transact and carry on a general investment dealer and brokerage business and agency, under the name of \"Wilbank Investments Ltd.\", with a capital stock of $50,000.divided into 50,000 shares of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of September, 1950.L.DÉSILETS, 28503-o Deputy Attorney General.W.J.Keating & Sons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze septembre 1930, constituant en corporation: John David Hackctt, avocat, Hannah Grace McKeil, sténographe, tous deux de la cité de Montréal, et William Vincent Manning, gérant de bureau, de Lachine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de quincaillerie, manufacturiers, entreposeurs, fournisseurs, entrepreneurs, négociants, constructeurs, agents, plombiers, ferblantiers, couvreurs et réparateurs, sous le nom de \"W.J.Keating & Sons Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à la Chambre 1606, 507 Place d'Armes, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze septembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28503 L.DÉSILETS.L'Evêque Catholique Romain des Trois-Rivieres The Roman Catholic Bishop of Trois-Rivieres Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des évêques catholiques romains (14 George VI, chapitre 76), il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du 3 octobre 1950, constituant en corporation \"L'Évêque Catholique Romain de Trois-Rivières\"\u2014\"The Roman Catholic Bishop of Trois-Rivières\".Le siège social de ladite corporation est situé aux Trois-Rivières.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 6 octobre 1950.Le Sous-secrétaire de la province, 28504-o JEAN BRUCHÉSI.W.J.Keating & Sons Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of September, 1950, incorporating: John David Hackctt, advocate, Hannah Grace McKeil, stenographer, both of the City of Montreal, and William Vincent Manning, office manager, of Lachine, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses of hardware merchants, manufacturers, warehousemen, suppliers, contractors, jobbers, builders, agents, plumbers, tinsmith, roofers, and repairmen, under the name of \"W.J.Keating & Sons Ltd.\", with a capital stock of $20,000.divided into 200 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Room 1606, 507 Place d'Armes, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of September, 1950.L.DÉSLLETS, 28503-o - Deputy Attorney General.L'Evêque Catholique Romain des Trois -Rivieres The Roman Catholic Bishop of Trois-Rivieres Notice is hereby given that under the provisions of the Roman Catholic Bishops Act (14 George VI, chapter 76), letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of October, 1950, to incorporate \"L'Évêque Catholique Romain de Trois-Rivières\"\u2014\"The Roman Catholic Bishop of Trois-Rivières\".The head office of the said corporation will be at Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixth day of October, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28504 Under Secretary of the Province. \u2022 Ventes pour taxes Sales for Taxes AVIS DE VENTE-D'IMMEUBLES Avis public est par les présentes donné que les propriétés immobilières ci-après mentionnées et plus spécialement désignées dans une cédule déposée dans mon bureau, le 25e jour de septembre 1950, seront vendues par moi, à mon bureau, dans»la Cité de Montréal, le VENDREDI, PREMLER jour de DECEMBRE 1950, à DIX heures du mutin, à raison d'une réclamation de la Cité de Montréal, pour taxes et contributions foncières annuelles ou spéciales ou pour arrérages de taxes consolidées.NOTICE OF SALE OF IMMOVABLES Public notice is hereby given that the immovable properties hereinafter mentioned, and more particularly described in a schedule filed in my office, on the 25th day of September 1950, will be sold by me, at my office, m the City of Montreal, on FRIDAY, the FIRST day of DECEMBER 1950, at TEN o'clock in the forenoon, upon claim by the City of Montreal for annual or special real estate taxes and assessments or for arrears of consolidated taxes.Compte N° ] Account No.\tDivision d'enregistrement Registration Division\tCadastre\tSubdivision\tN° Civique, Rue Civic No., Street\tNom du propriétaire Name of proprietor\tTaxes au 30 avriM950 Taxes as at April 30th 1950 121059\tQuartier Ste-Anne.\tp897\t\t\tValerie Catherine Filiatrault, épse de-wife of John Henry\t791.46 \tSt.Ann's Ward.\t\t\t\t\t Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.121586 Quartier Ste-Anne.St.Anil's Ward.p897.Centre.Valerie Catherine Filiatrault, épse de-wife of Jolu* Henry Geary.'.T.I 688.47 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.arrérages de taxes.170927\tQuartier St-Lâurent .St.La rence Ward.\t168.\t29.p30.190800\t\t72,p7Q p71.\t \tSt.Louis Ward.\t\t 201224\tQuartier St-Jacqucs .St.James Ward.\t1199.\tp3.4.210528\tQuartier Ste-Marie.St.Mary's Ward.\t1225.\t48.2114 St-Urbain 7-11 Vitro Est-East.430 Sherbrooke Est-East.4021-23 Cartier .Angelo Mastrolorito.Angelo Mastrolorito.La Jeunesse Etudiante Catholique.Emile Armand Labelle.341.85 222.96 1,794.00 255.37 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.240240\t 240256\t 240325\tPar.Montréal.250607\t 280658\tQuartier St-Louis.St.Louis Ward.281503\tSt.Louis Ward.281603\tSt.Louis Ward.281626\tSt.Louis Ward.2604.2739.p2626.p2626.p2625.512.513.971.903.917.1049.89.8-3.p7-3, 8-2.p7-2, 8-1.p7-l.29A.p28A.2736-48 Cent o.276r-67 Château-guay.2506-16 Centre.2776-86 De Châ- teauguay.1121-25 d'Argen- son.2251-61a Workman.3726 Ave Coloniale.3834 St-Denis.170-176 Roy Est 3792-94 Ave Do l'Hôtel-de-Ville.51 Roy Est- 3801 St-Domi-nique.Be St Realties Corporation Be St Realties Corporation Be St Realties Corporation Charlotte Chrétien, ve de-wid of Fortunat Lacombe.Rodolphe Cerat.La fédération diocésaine de Montréal.De la jeunesse catholique du Canada Incorporée Matelas Montréal Incorporée.Rachel Shrier.789.80 1,046.76 770.88 351.16 250.84 630.90 697.43 165.75 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.281685 281815 310867 VillageSfc-Jean-Baptiste Quartier St-Louis.St.Louis Ward.Village Hochelaga.108.p96.p910.29.455-1.455-2-1.120 Ave Duluth est.Bât.-Building.De Bullion.2189-93 Davidson Jewish Peretz School Inc.Charles-Auguste Fortin.Patrick Tanguay.2,272.96 65.74 361.82 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lLth, 1950, Vol.82, No.LI 2585 2588 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, IL octobre 1950, Tome 82, N° Ll 311145|Village Hochelaga.[29____|872.|2684-90 Aylwin.|Jean Carrino.:| 550.95 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation of tax arrears.arrérages de taxes.311842 312037) 312038 312383 312495 321019 330229 330230 332503 332504 332505 332506 332507 350519 Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Village Hochelaga.Par.Longue Pointe.18.18., 18.80.23.23.18.18.1A 1A 1A 1A 1A 536.1073.1072.2210-14 Ave Bourbonnièro.Ave Bourbonnière Ave Bourbonnière p54.p286,p287 p2?8,884.427.1464.1465.1689.1688.1687.1686.1685.Lionel Beaudet.3100 Do Rouen .3580 Hochelaga.3693-97 Stc-Cathcrine E.Ave d'Orléans Ave d'Orléans Leclaire.Le claire.Leclaire.Leclaire.Leclaire.Succ.-Est.Eva Duguay, we do-wid.of L.J.A.Champagne.Succ.-Est.Eva Duguay, we de-wid.of L.J.A.Champagne.Metal Heat Treating Co.Napoléon Rajotto.Annette Anna Daoust, we de-wid.of François Xavier Des-rochors et al.Succ.-Est.Eva Duguay, we de-wid.of L.J.A.Champagne.Succ.-Est.Eva Duguay, we de-wid.of L.J.A.Champagne.J.Paul Lebel.J.Paul Lebel.J.Paul Lebel.J.Paul Lebel.J.Paul Lebel.Olivette Tourangeau, épse de-wifo of Charles Paul., 249.17 39.93 39.93 471.56 462.78 894.31 13^38 13.38 36.24 36.24 36.24 36.24 36.24 396.90 3.1.4974 Notre-Dame1 1.2.Est-East.Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.350520 Par.Longue Pointe.\t3.\t2.\t1.\t3.\t2.\t1.4980 Notre-Dame Est-East.Olivette Tourangeau, épse de-wifo of Charles Paul.395.79 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.363328|Par.Longue Pointe.1391.370293 370294 400383 413847 455118 455119 472752 475329 500493 540920 540921 643007 560798 580779 584374 686097 610596 653274 Par.Longue Pointe.Par.Longue Pointe- Par.Montréal.Par.Montréal.Par.Montréal.Par.Montréal.Villago Côte des Neiges 400.400., 3929.3912.161.151.150.Village Côte des Neiges VillageSt-Jean-Baptiste Village Côte St-Louis.Village Côte St-Louis.Village Côte Visitation.Village Côte St-Louis.Par.St-Laurent.566,567.12626 De Bruxelles 847.846.6a, 6b.Mousseau.Mousseau.255.534.533.277.70.15.336.336.Village Côte St-Louis.Village Côte St-Louis.Village Côte St-Louis.Village Côte Visitation.12., 162.11.634.11.10.8.207, 206.2216-26 Ave De l'Eglise.2424 Springland.Ave Chester.Ave Chester.5035 Mira Road .496.1289.603.16.p809.132, 131.pllôl.1746.1745.p631, 632 .895, 358.Goyer.4067-71 Ave De l'Hôtel de Ville.Ave Papineau____ Ave Papineau.2245 Boul.St-Joseph E.5641-45 Ave de L'Esplanade.7202-04 Stuart Ave.931 Jean-Talon O.-W.6541-43 Clark.6792-94 Aima.6201-11 De St-Vallier.5937 3e Avenue Napoléon Gaboury.René Demers.René Demers.Clorinda Labelle, we de-wid.of Louis Charbonneau et al.Marcel Lavoie.C.-Romulus Lasalle.C.-Romulus Lasalle.Géraldine Ida Hoffman, épse de-wifo of Moses Lewis Turkenik.Robert Cameron Duff.Thomas-Joseph Chase.Joseph-Achille Francœur.Joseph-Achille Fancœur.Joseph-L.Chargonneau.Matelas Montréal Incorporée.Marie Marcantoriatos, we de-wid.of Dennis Tomotheatos; Crate and Box Mfg.Corp.Aurore Guilmette, we de-wid of Horace Beaulieu.Estello Meilleur, épse de-wife of Emile Desjardins., William Begg.63.81 19.50 19.50 464.01 125.26 32.41 28.41 1,128.97 8.74 342.77 100.34 100.34 2,053.78 621.97 1,473.42 404.26 234.10 675.08 227.11 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lLth, I960, Vol.82, No.il 2587 655152\tVillage Côte Visitation.\t201.655343\tVillage Côte Visitation.\t177.660525\tVillage Côte Visitation.\t178.671040\tVillage Côte Visitation.\tpl66.681110\tPar.Sault au Récollet.\t490.444.9, 8.p96.p97.452.6736-40 12 Avenue.5363, 12e Avenue 5421-23, 15e Avenue.5744 Franchère.Gaston Rondeau.Elie Garby.321.89 174.53 314.38 165.60 Henri Jarry.11,694.6l Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation Boyer.Eva Paskevitch, we de-wid of Peter Paskevitch et at.Emmanuel Fiedler.arrérages de taxes.682269 683554 684180 Par.St-Laurent.Par.St-Laurent.Village Côte St-Louis.2630.\t598, 2629.\t282, 8.\tP451 of tax arrears.DeChâteaubriand.7827-31 Lajeu-nesse.M 7032 De St-Vallier Henri Jarry.Terezia Vosko, épse de-wife of Joseph Boy man ky.Germaine Préfontaine, épse de-wife of Sylva Sills.762.15 410.33 214.88 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.C91985 Par.Sault au Recolle t.490.417.297.06 Ch.de la Côte Henri Jarry.St-Michel.I Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.091986 Par.Sault au Récollet.490.418.748.38 .Ch.de la Côte Henri Jarry.St-Michel.| Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.09307o|Par.St-Laurent.I287.Jp77,78-JBerri.JLaura Laçasse et al.| 13.01 Sujet à la créance privilégiée de la consolidation des Subject to the privileged debt of the consolidation arrérages de taxes.of tax arrears.694676\t\t270.\t127 .\t9462-64 Basile\t\t351.67 \t\t\t\tRouthier.590 Louvain.\t\t 090095 715854\t\t268.\t244.P225.\tSt-Hubert.\tRoland Jarry et al.\t93.80 129.43 \tPar.Sault au Récollet.\t126.\t222.\t10440 Ave Larose.\t\t \t\t\t221.\t\t\t 715856 731188\tPar.Sault au Récollet.Par.Sault au Récollet.\t126.\t220.\t\t\t10.74 422.72 \t\t268.\t358.\t10285 Waverley.\t\t \t\t\tp359.\t\t\t 741611\tPar.Sault au Récollet.\t301.\t242.\tAve Bois de\t\t7.64 \t\t\t\tBoulogne.\t\t 741612\tPar.Sault au Récollet.\t301.\t241.\tAve Bois de\t\t7.64 \t\t\t\tBoulogne.\t\t 741613\tPar.Sault au Récollet.\t301.\t240.\tAve Bois de\t\t7.54 \t\t\t\t' Boulogne.\t\t 741614\tPar.Sault au Recollet.\t301.\t239.\tAve Bois de\t\t7.64 \t\t\t\tBoulogne.\t\t 741617\tPar.Sault au Récollet.\t301.\t236.\tAve Bois de\t\t7.64 \t\t\t\tBoulogne.\t\t 743530\t\t26.\t965 .\t\t\t2.45 Conformément au premier alinéa de l'article In accordance with the 1st paragraph of 401 de la Charte de la Cité de Montréal, tel Art.401 of the Charter of the City of Montreal, qu'amendé par la loi 1 George VI, chap.103, as amended by the Act 1 George VI, chap.103, sec.62, un dépôt de 10% du montant de l'éva- section 62, a deposit of 10% of the amount of luation municipale inscrite au rôle en vigueur the municipal valuation entered on the roll in lors de cette vente, sera exigible du plus haut force at the time qf the sale, shall be exacted enchérisseur avant l'adjudication finale.from the highest bidder, before final adjudication.Le Shérif, L.-P.CAISSE, L.-P.CAISSE.Sheriff.Bureau du Shérif, Sheriff's Office, Montréal, le 12 octobre 1950.28527-0 Montreal, October 12th, 1950.28527-0 Province de Québec Cite de St-Lambert Comté de Chambly Province of Quebec City of St.Lambert County of Chambly Avis public est, par les présentes, donné que la Public notice is hereby given that the Quebec Commission Municipale de Quebec, par un municipal Commission by an order dated October Arrêté en date du 3 octobre, 1950, a ordonné 3rd, 1950, has directed the undersigned in con- au soussigné, conformément aux dixpositions formity with the provisions of Article 54 of the 2588 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Il octobre 1950, Tome 82, N° Il de l'Article 54 de la Loi de la Commission Municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Cité de Saint-Lambert, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du Conseil à l'Hôtel de ville de la cité de Saint-Lambert, 35 rue Aberdeen, Saint-Lambert, MERCREDI, le (8) HUITIEME jour de NOVEMBRE 1950, à DIX heures du matin, heure normale de l'est.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes devenues exigibles le ou avant le 1er décembre, 1948, auront été payées avant le moment de la vente.La vente des immeubles décrits dans la première section du présent avis sera faite sujette au droit de retrait mais suivant les dispositions de l'article 74 de la Loi de la Commission Municipale de Québec, la vente des immeubles décrits dans la deuxième section sera finale et le droit de retrait ne pourra pas être exercé, tous lesdits immeubles étant des terrains vacants et des lots à bfitir d'une évaluation municipale ne dépassant pas mille dollars.Quebec Municipal Commission Act.(R.S.Q-1941, Chapter 207) to sell the immovables herein, after described to satisfy the payment of the arrears of taxes due to the City of St.Lambert with interest and costs, and consequently said immovables will be sold by Public auction in the council Chamber at the city Hall of the City of St.Lambert, 35 aberdeen street, St.Lambert, on WEDNESDAY, the EIGHTH day of NOVEMBER, 1950, at TEN o'clock in the forenoon, Eastern Standard Time.However, shall be excluded from the sale those immovables on which the taxes that became exigible on or l)efore December 1st, 1948, shall have been paid before the actual sale.The sale of the immovables described in the first section of the present notice will be subject to the right of redemption, but according to the provisions of Article 74 of the Quebec Municipal Commission Act, the sale of the immovables described in the second section shall be final and the right of redemption cannot be exercised, all said immovables being vacant lands and building lots of a municipal valuation not exceeding one thousand dollars.Première section \u2014 Immeubles sujets au droit de retrait Part one \u2014 Immovables subject to the right of redemption N° rôle Roll No.Nom Name Sub-Div.300 111 R.B.Bissell & B.B.Tarlton O.H.Lansing.Description: La partie Sud-Est du Lot N° 162-1075 mesurant cinq pieds en largeur par quatre-vingt-cinq pieds de profondeur et borné au front par l'avenue Birch, à l'arrière par une ruelle commune portant N° 162-1065, sur un côté par le lot N° 162-1074 et sur l'autre côté par le résidu du dit lot N° 162-1075 avec bâtisse.620 Pt.1075 1074 1073.Description: The South-East part of lot No.162-1075 measuring five feet in width by eighty-five feot in depth and bounded in front by Birch Avenue, in rear by a common lane bearing No.162-1065, on one side by lot No.162-1074 and on the other side by the residue of said Lot No.162-1075, with building thereon.1111 Peter Zenchik.50 Macaulay Ave.261 Description: La partie Nord-Ouest du lot N° 261-72 mesurant dix pieds en largeur par cent pieds en profondeur et borné par l'Avenue Macaulay au front, à l'arrière par une ruelle commune portant le N° 261-80 sur un côté par le lot N° 162-71 et de l'autre côté par le résidu du lot N° 162-72 avec bâtisse.Pt.72 71 70 Description: The North-West part of lot No.261-72 measuring ten feet in width by one hundred feet in depth and bounded in front by Macaulay Avenue, in rear by a common lane bearing No.261-80, on one side by lot No.162-71 and on the other side by the residue of Lot No.162-72, with building thereon.Deuxième section cr of directors of \"M.I.Viau & Fils Limitée\" be increased from three (3) to four (4).Adopted.\" Certified True Copy.ROLAND CADLEUX, 28505 Secretary.Richer Drug Co.Amendment to By-law No.8, as passed by the directors and sanctioned by the shareholders on September 15th,- 1950, and concerning an increase in the directorate of the above named Company from three to four.' \"Upon motion duly made and seconded, it was unanimously resolved that the first line of By-Law No.8 of the by-laws of the company be struck and replaced by the following: \"The affairs of the Company shall be managed by a board of four (4) directors.\" Certified True Copy.H.W.RICHER, 28506-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Caisse de Crédit des Employés de Tramways\", under date the 8th day of September, 1950, whereof the head office is at Montreal, judicial district QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lLth, 1950, Vol.82, No.LI 2591 que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 25 septembre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28515-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de Québec CITE DE ROUYN Avis public est par les présentes donné que les obligations émises par la Cité de Rouyn sous l'autorité de son règlement N° 70, Série \"C\", ont été désignées par le sort pour être rachetées au pair le 1er décembre 1950: Série \"C\" Dénomination de $100.00: 50, 202, 255.Dénomination de $500.00:18, 43, 171,198,247, 201,318, 340, 357; Dénomination de $1,000.00: 1, 29, 48, 87, 159.Donné à Rouyn, ce 7ième jour d'octobre 1950.Le Secrétaire-trésorier, 28534-0 GERARD BEAUCHEMIN of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of September, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28515 Under Secretary of the Province.Canada, Province of Quebec, CITY OF ROUYN Public notice is hereby given that the bonds issued by the City of Rouyn under authority of its by-law No.70, Series \"C\", have been drawn by lots for redemption, at par, on the 1st of December 1950.Series \"C\" Domination of $100.00: 56, 202, 255.Domination of $500.00: 18, 43, 171, 198, 247, 261,318,340,357.Domination of $1,000.00: 1, 29, 48, 87, 159.Given at Rouyn, this seventh day of October 1950.GERARD BEAUCHEMIN, 2S534 Secretary-Treasurer.Bills, Assemblée législative Avis de l'Assemblée Législative Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Aux termes du règlement, les bills privés devront être déposés avant le 18 octobre 1950 et présentés avant le 29 novembre 1950, les pétitions introductives de bills privés devront être présentées avant le 18 novembre 1950 et reçues avant le 23 novembre 1950, et les rapports de comités élus chargés de l'examen des bills privés devront être reçus avant le 13 décembre 1950.Québec, le 5 octobre 1950.Le Greffier, 2S198-40-5-o ANTOINE LEAHEUX.Bills, Legislative Assembly Notice of the Legislative Assembly Relating to private bills to be introduced during the coming session.Under the rules and standing orders, private bills must be deposited before the 18th October 1950 and introduced before the 29th November 1950, petitions for the introduction of private bills must be presented berore the 18th November 1950 and received before the 23rd November 1950, and the.reports from select committees charged with the examining of private bills must be received before the 13th December 1950.Quebec, October 5th, 1950.ANTOINE LEMIEUX, 28498-40-5-o Clerk.Compagnie autorisée à faire des affaires Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Brussels Corporation for International Trade, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et sujets aux mêmes formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.L'agent principal de ladite compagnie dans cette Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure intentée contre elle, est M.W.H.Laidlcy, de la cité de Montréal.Le bureau principal de la corporation dans la Province est à 507 Place d'Armes, en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 10 octobre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28507 JEAN BRUCHÉSI.Companie Licensed to do Business Notice is hereby given that the \"Brussels Corporation for International Trade\" has been authorized to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be, limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The chief agent of the said Company in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it is W.H.Laidley.of the city of Montreal.The principal office of the Corporation for this Province is established at 507 Place d'Armes, in the said City of Montreal, Judicial District of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of October, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28507-o Under Secretary of the Province. 2592 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U octobre 1960, Tome 82, N° Il Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Charms Company\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et sujets aux mêmes formalités prescrites par les Lois existantes de cette Province.L'agent principal de ladite compagnie dans cette Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure prise contre elle, est M.W.H.Laidley, 2000 Edifice Aldred, 507 Place d'Armes, de la cité de Montréal.Le bureau principal de la corporation dans cette Province est établi à 1167 ave Hickson, dans la cité de Verdun, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 10 octobre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28507 JEAN BRUCHÉSI.Avis est donné que la compagnie \"Koninklijke Lutchtvaart Maatschappij N.V.\" (K.L.M.Royal Dutch Airlines) a été autorisée a exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et sujets aux mêmes formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.L'agent principal de ladite compagnie dans cette Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure intentée contre elle, est M.Herman Richard Sem-melink, de la cité de Montréal.Le bureau principal de la corporation dans cette Province est à l'édifice \"The International Aviation\" rue Dorchester ouest, dans lesdites cité et district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le sept octobre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28507 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the \"Charms Company\" has been authorized to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The chief agent of the said Company in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it is W.H.Laidley, 2000 Aldrcd Building, 507 Place d'Armes, of the City of Montreal.The principal office of the Corporation for this Province is established at 1167 Hickson Ave., in the City of Verdun, Judicial District of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of October, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28507-o Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the \"Koninklijke Lutchtvaart Maatschappij N.V.\" (K.L.M.Royal Dutch Airlines) has been authorized to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The chief agent of the said Company in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it is Herman Richard Semmelink, of the City of Montreal.The principal office of the Corporation for this Province is established at the International Aviation Building, Dorchester Street West, in the said City and in the Judicial District of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of October, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28507-o Under Secretary of the Province.Demande à la Législature AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la \"Ville de Matane\" demandera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session, l'adoption d'une loi modifiant la charte de ladite Ville, aux fins suivantes: Imposer une taxe de vente n'excédant pas 2%.Matane, le 23 septembre 1950.Les Procureurs de la Pétitionnaires, 28454-40-4-o GAGNON & GAGNON.AVIS Avis est par les présentes donné que Mlle.Simone Martineau, de la cité et district de Montréal sollicitera auprès de la Législature de la province de Québec à sa prochaine session l'adoption d'une loi l'autorisant à vendre, et à disposer sans formalités en complète propriété comme seule propriétaire, l'immeuble nos.civi- Application to Legislature PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the \"Town of Matane\" will apply to the Legislation of the Province of Quebec, at its next session, for the passing of an Act amending the charter of the said Town, for the following purposes: To levy a sale's tax not exceeding 2%.Matane, September 23rd, 1950.GAGNON & GAGNON, 28454-40-4-o Attorneys for the Petitioner.NOTICE Notice is hereby given that Miss Simone Martineau of Montreal city and district, will apply to the Legislature of the province of Quebec at its next session for the passing of an Act, authorizing her to sell and dispose without formalities in complete ownership, as sole owner, the property bearing civic numbers 421-23-25 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lkth, I960, Vol.82, No.11 2593 ques 421-23-25 rue Malines, 1200-33A.St-Jacques, Montréal, légué avec restrictions, par feu l'Honorable Paul-G.Martineau de la Cour Supérieure, Montréal.5 oct.1950.Le Procureur de la requérante, JEAN MARTINEAU, 28512-41-4-0 414 St-Jacques Ouest, Montréal.Malines St.1200-33A.St-James, Montreal, willed with restrictions by the late Honourable Paul-G.Martineau of the Superior Court, Montreal, October 5, 1950.JEAN MARTINEAU, Attorney for the petitioner, 28512-41-4-0 414 St-James West, Montreal.AVIS Avis public est donné par les présentes que la \"Canadian Westinghouse Company Limited\", s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, ou à celle qui la suivra, pour la passation d'une Loi fixant l'évaluation des propriétés de ladite compagnie, en la cité des Trois-Rivières, province de Québec, à toutes fins municipales et scolaires, pour une période de dix ans.Montréal, le 10 octobre 1950.Les Procureurs du pétitionnaire, 28521-41-4 WILSON & HOME.NOTICE Public notice is hereby given that \"Canadian Westinghouse Company Limited\" will apply to the Quebec Legislature, at its next Session, or the one following the same, for the passing of an Act to fix the valuation of the properties of the said Company in the City of Three Rivers, Province of Quebec, for all municipal and school purposes, for a period of ten years.Montreal, Octol>cr 10th, 1950.WILSON & HOME, 28521-4l-4-o Attorneys for the Petitioner.AVIS t Avis public est par les présentes donné que Roderick B.Masson, cultivateur, de la ville et du district de Terrebonne, Alphonse Milette, administrateur, et Léon Masson, courtier, tous deux de la cité et du district de Montréal, Charles de Lotbinière Harwood, gérant, de la cité d'Ottawa, province d'Ontario, et Jaque Masson, capitaine paie-maître, de la cité et du district de Montréal, tous cinq agissant en leur qualité d'exécuteurs testamentaires et fidéicommissaires de la succession de feu l'Honorable Joseph Masson, s'adresseront à la législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour obtenir une loi spéciale pour proroger le partage de la dite succession et de chacun des lots qui la composent, et pour autres fins.Montréal, le 10 octobre, 1950.Beatjlietj, ,Gouin, Bourdon, Beaulieu & Casgrain, Les Procureurs des requérants es-qualité.28522-41-4-0 NOTICE Public notice is hereby given that Roderick B.Masson, Farmer of the Town and District of Terrebonne, Alphonse Milette, Administrator and Leon Masson, Broker, both of the City and District of Montreal, Charles de Lotbinière Harwood, Manager, of the City of Ottawa, Province of Ontario, and Jaque Masson, Captain Pay-Master, of the City and District of Montreal, all five acting in their quality of testamentary executors and trusteed of the Estate of the late Honourable Joseph Masson, shall apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next Session, in order to obtain a special law for the purpose of postponing the partition of the Estate and of the various lots of said Estate and for other purposes.Montrea, October 10th, 1950.Beaulieu, Gouin, Bourdon, Beaulieu & Casgrain, Attorneys for the Petitioners es-quality.28522-41-4-0 Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS NOTICE Cadastre officiel de la paroisse de Beauport Officiai Cadastre of the Parish of Beauport (maintenant partie de la Ville de Courville) (Now part of the Town of Courville) Régi Division d'enregistrement de Québec.tration Division of Quebec.Avis est par la présente donné que le lot Notice is hereby given that lot 59-A-16 is 59-A-16 est annulé en vertu de l'article 2174A cancelled in virtue of Article 2174A of the civil du Code civil.Québec, le 28 septembre 1950.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 28526-o A VILA BÉDARD.Code.Quebec, September the 28th, 1950.Department of Lands and Forests, Cadastra Branch, A VILA BÉDARD, 28526-0 Deputy Minister.Greffe de notaire Notarial Record Avis est par le présent donné, conformément aux dispositions du Code du Notariat, que le Conseil de la Chambre des Notaires, à sa réunion qui a été tenue à Montréal, le 4 octobre 1950, a accordé à Me Paul-René Lavoie, notaire demeurant et exerçant à Montréal, district Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Notarial Code, that the Council of the Board of Notaries, at its meeting held in Montreal on the 4th of October 1950, has granted 'to Me Paul-René Lavoie, Notary residing and practising at Montreal, Judicial District 2594 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 octobre 1960, Tome 82, N° Al judiciaire de Montréal, la tansmission des minutes, répertoire et index de Me Victor Joan-nette, notaire décédé.Montréal, 11 octobre 1950.Le Secrétaire-trésorier de la Chambre, des Notaires, 28516-0 ARTHUR COURTOIS.of Montreal, the transfer of the minutes, repertory and index of Me Victor Joannette, deceased Notary.Montreal, October 11th 1950.ARTHUR COURTOIS, Secretary-Treasurer of the Board, 28516-o of Notaries.Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DE HULL \u2014 BAR OF HULL candidat8 pour l'admission a l'étude du droit Candidates for the admission to the study of law Noms\tPrénoms\t\tResidence\tCollèges \u2014\t\u2014\tAge\t\u2014\t_ Names\tSurnames\t\tResidence\tColleges \t\t23 23 21\tOttawa .\tUniversité d'Ottawa.Université d'Ottawa.Université de Montréal.\tGilles.\t\t\t \tAndres-Charles.\t\tOttawa\t \t\t\t\t Hull, le 3 octobre 1950.\u2014 Hull, October 3, 1950.Le Secrétaire du Barreau de Hull, R.MILLER WALLACE, 28533-4l-2-o \u2022 Secretary of the Bar of Hull.BARREAU DE QUEBEC \u2014 BAR OF QUEBEC Candidats pour l'admission a l'étude du droit Candidates for the admission to the study of law Noms Names Prénoms Surnames Age Résidence Residence Rochette .Morin.Migneault .Bernier.Rousseau.Lacroix.Harvey.Cannon .Lacourcière Gobeil____ Jacques.Andrée .Yvan.Jean-Paul.Madeleine Jean-Luc.Gaston .Hélène.Leopold.Maurice .20 19 21 22 23 21 28 20 21 29 Charlesbourg.Sainte-Claire-Dorchester.Québec.Québec.Québec.Charny.St-Joseph d'Alma.Québec.Sudbury, Ont.Baie St-Paul.28533-4 l-2-o Le Secrétaire du Barreau de Québec, J.-CHARLES-V.GRAVEL, Secretary of Quebec Bar.Liquidation, avis de: Avis est donné par les présentes que lors d'une asemblée générale spéciale des actionnaires de la \"Beresford Realty Company Limited\", dûment convoquée à cet effet, et tenue le 14 décembre 1949, une résolution fut passée pourvoyant à la liquidation de ladite compagnie, sonformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, S.R.Q.1941, chapitre 278, et que M.C.F.Ritchie, de \"Ritchie, Brown & Company\" a été nommé liquidateur.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce sixième jour d'octobre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28517 JEAN BRUCHÉSI.Winding up Notice : Notice is hereby given that, at a special general meeting of the Shareholders of the \"Beresford Realty Company Limited\" duly convened for such purpose and held on the 14th December, 1949, a resolution was passed providing for the winding up of the said Company, pursuant to the provisions of the Winding-up Act, R.S.Q.1941, chapter 278, and that Mr.C.F.Ritchie of Ritchie, Brown & Company was appointed liquidator.Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of October, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28517-0 Under-Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October mh, 1960, Vol.82, No.11 2595 Avis de nomination du liquidateur de la Compagnie d'Assurance Mutuelle Contre le Feu de*la Paroisse de St-Etienne de Bolton Avis est par les présentes donné qu'à une assemblée générale spéciales des membres de la Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le Feu de la Paroisse de St-Étienne (je Bolton, tenue le 30 septembre 1950, le soussigné a été nommé liquidateur de ladite compagnie, conformément aux dispositions de l'article 276 de la Loi des Assurances de Québec.Toute réclamations contre ladite compagnie devra être attestée sous serment et produite entre mes mains dans les trente jours du présent avis.Donné conformément aux dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, ce trentième jour de septembre, 1950.Le Liquidateur, PAUL TALBOT, 28467-40-2-0 Waterloo, P.Q.Notice op Appointement or the Liquidator of Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le Feu de la Paroisse de St-etienne de Bolton Notice is hereby given that on the 30th of September, at a general special meeting of the members of Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le Feu de la Paroisse de St-Étienne de Bolton, the undersigned was appointed Liquidator of the affairs of the said company pursuant to the provisions of section 276 of Quebec Insurance Act.Any claim against the said company must be sworn to and filed with me within thirty days following the present notice.Given pursuant to article 872 of the Code fo Civil Procedure, this thirtieth day of September, 1950.PAUL TALBOT, Liquidator, 28467-40-2-o Waterloo, P.Q.Proclamation Proclamation Canada, Province de Québec.[L.S.] GASPARD FAUTEUX Canada, Province of Quebec.[L.S.] GASPARD FAUTEUX GEORGE VI, par la grace de Dieu roi de Grande- GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Bretagne, d'Irlande et des territoires britanni- Britain, Ireland and the British Dominions ques au delà des mers, défenseur de la foi: beyond the Seas, King, Defender of the Faith.A nos très aimés et fidèles conseillers les mem- To~ Our Beloved and Faithful Councilors the brcs du Conseil législatif et de l'Assemblée Members of the Legislative Council and of the legislative de la Province de Québec.Legislative Assembly of the Provice of Quebec: Salut.Greeting.Attendu que, pour diverses considérations, il est à propos de convoquer la Législature de la province de Québec pour l'expédition des affaires, Nous vous convoquons par les présentes pour le huit novembre prochain et, en conséquence, nous mandons et ordonnons de vous assembler à cette date au palais législtif, en la cité de Québec, pour y expédier les affaires de la Province et y examiner, discuter et décider les questions qui vous seront soumises.En foi de quoi Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icclles apposer le grand sceau de la province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Monsieur GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., lieutenant-gouverneur de ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le quatrième jour d'octobre, l'an de grâce mil neuf cent cinquante et de Notre règne le quatorzième Par ordre, Le Secrétaire de la chancellerie à Québec, 2S499-40-5-o ANTOINE LEMIEUX.Whereas for various considerations, it is expedient to convoke the Legislature of the Province of Quebec for the dispatch of business, We hereby convene you for the EIGHTH day of NOVEMBER next and, accordingly, command and order you to mette on such date at the Parliament Buildings, in the City of Quebec, for the dispatch of the business of the Province and to examine, discuss and decide the questions to be submitted to you.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be here unto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved The Honourable Mr.GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of the said Province.At Our Government House in Quebec, this fourth day of October, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty and the fourteenth year of Our Reign.By command.ANTOINE LEMIEUX, Clerk of the Crown in Chancery, 2^499-40-5 at Quebec.Sièges sociaux Administration Inc.Avis est donné que la compagnie \"Administration Inc.\", constituée en corporation en date Head Offices Administration Inc.Notice is hereby given that the \"Administration Inc.\" company incorporated by letters 2596 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 14 octobre 1960, Tome 82, N° 41 du dix-huitième jour de septembre 1950, et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 437 ouest de la rue Saint-Jacques.A compter de la date du présent avis, le dit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce vingt-cinquième jour de septembre 1950.La Secrétaire, 28508-o PAULINE CABANA.Province de Québec \u2014 District de Montréal Wilbank Investments Ltd.Avis est donné que la compagnie \"Wilbank Investments Ltd.\", constituée en corporation\" par lettres patentes en date du 6 septembre 1950 et ayant son siège social en la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 1181 ouest, rue Ste-Catherine.A compter de la date de cet avis, ladite adresse sera considérée par la compagnie comme étant celle de son siège social.Daté à Montréal, le 25 septembre 1950.(Sceau) Le Président, 28509 SAMUEL ASTROF.patent, on the eighteenth day of September 1950, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at No.437 West, St.James Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this twenty-fifth day of September 1950.PAULINE CABANA, 28508-o Secretary.Province of Quebec \u2014 District of Montreal Wilbank Investments Ltd.Notice is hereby given that \"Wilbank Investments Ltd.\", a company incorporated by Letters Patent dated September 6, 1950, and having its Head Office in the City of Montreal, has established its office at number 1181 St.Catherine St.W.From and after the date of the present notice, the said address will be considered by the Company as being that of its Head Office.Dated at Montreal, September 25, 1950.(Seal) SAMUEL ASTROF, 28509-o .President.Soumissions Tenders Province de Québec Ville de Loretteville (Comté de Québec) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées sur l'enveloppe \"Soumissions pour Obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-R.Durand, C.P.9, Loretteville, comté de Québec, jusqu'à 8 heures de l'après-midi, le 30 octobre 1950, pour l'achat de $100,000.00 d'obligations datées du 1er octobre 1950 et remboursables en séries en vingt ans, du 1er octobre 1951, au 1er octobre 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3^% Par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux offert peut être le même ou peut varier suivant les échéances.Ces obligations sont mises sous l'autorité du règlement d'emprunt N° 216 du conseil de la ville de Loretteville.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$100,000.00\u201420 ans Année Capital 1er octobre 1951.$3,500.00 1er octobre 1952.3,500.00 1er octobre 1953.4,000.00 1er octobre 1954.4,000.00 1er octobre 1955.4,000.00 1er octobre 1956.4,000.00 1er octobre 1957.4,500.00 1er octobre 1958.4,500.00 1er octobre 1959.4,500.00 1er octobre 1960.5,000.00 1er octobre 1961.5,000.00 1er octobre 1962.5,000.00 1er octobre 1963.5,500.00 1er octobre 1964.5,500.00 1er octobre 1965.6,000.00 1er octobre 1966.6,000.00 Province of Québec Town of Loretteville (County of Quebec) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, J.R.Durand, P.O.Box 9, Loretteville, county of Quebec, up to 8 o'clock in the evening on the 30th of October, 1950, for the purchase of $100,000 of bonds, dated October 1st, 1950, and redeemable serially in twenty years, from October 1st, 1951, to October 1st, 1970, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3%% per annum, payable semi-annually, on the 1st of April and 1st of October of each year.The rate offered may be the same or it may vary according to maturities.These bons are issued under authority of Loan-Law No.216 of the Council of the town of Loretteville.The table of redemption is as follows: Tables of Redemption \u2014 $100,000.00 \u2014 20 years Year Capital 1st October, 1951.$3,500.00 1st October, 1952 .3,500.00 1st October, 1953 .4,000.00 1st October, 1954 .4,000.00 1st October, 1955 .4,000.00 1 st October, 1956.4,000.00 1 st October, 1957.4,500.00 1st October, 1958 .4,500.00 1st October, 1959 .4,500.00 1st October, 1960.5,000.00 1st October, 1961.5,000.00 1st October, 1962.5,000.00 1st October, 1963 .5,500.00 1st October, 1964.*:.5,500.00 1st October, 1965.6,000.00 1st October, 1966.6,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October llth, 1950, Vol.82, No.11 2597 1er octobre 1967.6,000.00 1 er octobre 1968.6,500.00 1er octobre 1969.6,500.00 1er octobre 1970.6,500.00 Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré selon le cas, à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Loretteville.I^es coupons d'intérêt seront payables, au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital.Les dites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; si tel rachat est partial, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque certifié fait à l'ordre de la ville de Loretteville, pour un montant égal à 1% du montant de la présente émission, et devra spécifier si le prix offert comprend ou non les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et prises en considération à une séance spéciale du conxeil municipal qui se tiendra le trente octobre 1950 à 8.00 heures de l'après-midi, au Centre Paroissial 305, Racine, Loretteville.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Daté à Loretteville, comté de Québec, ce \u2022lième jour d'octobre 1950.Le Secrétaire-tésorier, J.R.DURAND, CP.9, Loretteville, 28511-0 Québec.1st October, 1967 .6,000.00 1 st October, 1968.6,500.00 1 st October, 1969 .6,500.00 1st October, 1970.6,500.00 The bonds will be payable to bearer or to the registered holder thereof as the case may be at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec, or at Loretteville.Interest coupons will be payable to bearer only, same places as the capital.These bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, pursuant to the provisions of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941; however if such redemption be partial, the bonds to be redeemed, will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque, made to the order of the town of Loretteville, for a sum equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a special meeting of the Municipal Council, to be held, on October 30, 1950, at 8 o'clock in the evening, at the parish Centre, 305 Racine, Loretteville.The Council does not bind itself, to accept the highest nor any of the tenders.Dated at Loretteville, county of Quebec, this 4th day of October, 1950.J.R.DURAND, Secretary-Treasurer, P.O.Box 9, Loretteville, 28511 Quebec.Province de Québec Commission scolaire de la ville de Victoriaville (Comté d'Arthabaska) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.Rod.Houle, sec-trésorier, C.P.22, Victoria-ville, comté d'Arthabaska, jusqu'à 8 heures P.M., lundi le 30 octobre 1950, pour l'achat de $85,000,-00 d'obligations de la commission scolaire de la ville de Victoriaville, datées du 1er novembre 1950 et remboursables par séries du 1er novembre 1951 au 1er novembre 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3%% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$85,000.00\u201420 ans Année Capital 1er novembre 1951.$3,000.00 1er novembre 1952.3,000.00 1er novembre 1953.3,000.00 1er novembre 1954.3,500.00 1er novembre 1955.3,500.00 1er novembre 1956.3,500.00 1er novembre 1957.3,500.00 1er novembre 1958.4,000.00 1er novembre 1959.4,000.00 1er novembre 1960.4,000.00 1er novembre 1961.4,500.00 Province of Quebec .School Commission of the Town of Victoriaville (County of Arthabaska) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, J.Rod.Houle, secretary-treasurer, P.O.Box 22, Victoriaville, county of Arthabaska, up to 8 o'clock in the evening, Monday, the 30th day of October, 1950, for the purchase of $85,000 of bonds of the School Commission of the Town of Victoriaville, dated the 1st of November, 1950, and redeemable serially from the 1st of November, 1951, to the 1st of November 1970, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3%% per annum, payable semiannually the 1st of May and 1st of November of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of Redemption \u2014 $85,000 \u2014 20 years Year _ Capital 1st November 1951.$3,000.00 1st November 1952.3,000.00» 1st November 1953.3,00.000 1st November 1954.3,500.00 1st November 1955.3,500.00 1st November 1956.3,500.00 1st November 1957.3,500.00 1 st November 1958.4,000.00 1st November 1959.4,000.00 1 st November 1960.4,000.00 1st November 1961.4,500.00 2598 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Il octobre 1950, Tome 82, N° U 1er novembre 1962.4,500.00 1er novembre 1963.4,500.00 1er novembre 1964.4,500.00 1er novembre 1965.5,000.00 1er novembre 1966.5,000.00 1er novembre 1967.5,000.00 1er novembre 1968.5,500.00 1er novembre 1969.5,500.00 1er novembre 1970.6,000.00 Le capital et les intérêts sont payables à Montréal, à Québec ou à Victoriaville.Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra specifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles de la ville de Victoriaville qui sera tenue lundi le 30 octobre 1950, à 8 heures P.M., au numéro 1 rue Notre-Dame-Ouest, Victoriaville.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Victoriaville (comté d'Arthabaska), ce 6ième jour d'octobre 1950.Le Secrétaire-trésorier, J.-ROD.HOULE.C.P.22 Victoriaville (Arthabaska) 285l8-o Province de Québec , Ville LaSalle (Comté de Jacques-Cartier) Avis est, par les présentes, donné que des soumissions cachetées marquées sur l'enveloppe \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, à l'hôtel-de-ville de Ville La-Salle, 13 rue Strathyre, Ville LaSalle, jusqu'à huit heures de l'après-midi, le 30 octobre 1950 pour l'achat d'obligations au montant de $850,-000.00 remboursables en séries vingt ans, datées du premier novembre 1950 et émises sous l'autorité des règlements d'emprunts Nos 334, 3îl, 342, 345, 346, 347, 349, 352, 353, 358, 359, 360, 361 et 362 du conseil de Ville LaSalle, dans le comté de Jacques-Cartier.Lesdites soumissions devront mentionner le taux d'intérêt desdites obligations au choix du soumissionnaire, lequel taux ne devra pas cependant pas excéder 3^% et le taux offert peut être le même ou peut varier suivant les échéances.L'intérêt sera payable semi-anhuellement.Le tableau d'amortissement est le suivant: 1st November 1962.4,500.00 1st November 1963.4,500.00 1 st November 1964.4,500.00 1st November 1965.5,000.00 1 st November 1966.5,000.00 1 st November 1967.5,000.00 1st November 1968.5,500.00 1 st November 1969.5,500.00 1st November 1970.6,000.00 Capital and interest are payable at Montreal, Quebec or at Victoriaville.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec 1941 ; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners of the Town of Victoriaville, to be held on Monday the 30th of October, 1950, at 8 o'clock P.M., at No.1 Notre-Dame street West, Victoriaville.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tender.Victoriaville (County of Arthabaska), this 6th day of October, 1950.J.ROD.HOULE, Secretary-Treasu rer.P.O.Box 22, Victoriaville (Arthabaska) 28518 Province of Quebec \" Town of LaSalle (County of Jacques-Cartier) Notice is hereby given that sealed tenders endorsed on the envelope \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, at the City Hall of the Town of LaSalle, 13 Strathyre avenue, Town of LaSalle, up to eight o'clock in the afternoon, the 30th of October 1950, for the purchase of $850,000.00 of bonds, redeemable in twenty years series, dated from November 1st, 1950 and issued under authority of Loan By-laws Nos.334, 341, 342, 345, 346, 347, 349, 352, 353, 358, 359, 360, 361 and 362 of the council of the Town of LaSalle, in the county of Jacques-Cartier.The interest rate on said bonds, shall be at the option of the tender, which rate shall not exceed, however, 3^% and the rate offered may be the same for the total issue or may vary according to maturities.Interest will be payable semi-annually.The table of redemption is as follows:' Le premier novembre Rachat annuel November the 1er Annual des années of the years Maturities 1951.$34,500.00 1951 .$34,500.00 1952.35,500.00 1952 .35,500.00 1953 .35,500.00 1953 .35,500.00 1954 .37,000.00 1954 .37,000.00 1955.37,000.00 1955 .37,000.00 1956 .40,000.00 1956 .40,000.00 1957.42,000.00 1957.:.42,000.00 1958 .43,500.00 1958 .43,500.00 1959.45,000.00 1959 .45,000.00 1960 .46,000.00 1960 .46,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lith, 1960, Vol.82, No.il 2599 1961 .\".49,000.00 1962 .50,000.00 1963 .52,000.00 1964.52,000.00 1965.55,000.00 1966 .31,000.00 1967.32,000.00 1968.32,500.00 1969 .34,000.00 1970 .66,500.00 Le capital et les intérêts seront payables au bureau principal de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, ou à tout autre endroit qui pourra être déterminé par résolution du conseil.Lesdites obligations pourront en vertu de l'au-, torité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, à toute date d'échéance d'intérêt, au pair; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Les soumissions seront prises en considération à la session spéciale dti Conseil de Ville LaSalle qui sera tenue le 30 octobre 1950, à huit heures du soir, à l'hôtel-de-ville, 13 rue Strathyre, Ville LaSalle.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'em-l'emprunt.L'intérêt couru sur les obligations devra s'ajouter au prix offert au moment de la livraison.Le conseil de Ville LaSalle se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ville LaSalle, ce 3 octobre 1950.Le Secrétaire-trésorier, 2S510-o ALBERT GRAVEL.1961 .49,000.00 1962 .50,000.00 1963 .52,000.00 1964 .52,000.00 1965 .55,000.00 1966 .31,000.00 1967 .32,000.00 1968 .32,500.00 1969 .34,000.00 1970 .66,500.00 Capital and interest will be payable at the principal office of the bank mentioned in the loan procedure, in Montreal, or at any other place which might be determined by resolution of the council.The said bonds may, under authority of Chapter 212 Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, on any interest payment date, at par; however, if such redemption be partial the bonds to be redeemed will be called in reverse order.The tenders will be considered at the special meeting of the council of the Town of LaSalle to be held the 30th of October 1950, at eight o'clock in the evening, at the City Hall, 13 Strathyre avenue, Town of LaSalle.Each tender moust be accmpanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The accrued interest on the bonds must be added to the price of the bonds at the time of their delivery.The council of the Town of LaSalle reserves the right of accepting neither the highest nor any of the tenders.Town of LaSalle, this 3rd day of October 1950.ALBERT GRAVEL, 28510-o Secretary-treasurer.Province de Québec Commission scolaire Saint-Bernard (Comté d'Abitibi-Est) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Roland Charest, secrétaire-trésorier, C.P.N° 2, Sullivan, comté d'Abitibi-Est, jusqu'à 8 heures p.m.jeudi le 2 novembre 1950, pour l'achat de $250,000 d'obligations de la Commission scolaire Saint-Bernard, comté d'Abitibi-Est, datées du 1er septembre 1950 et remboursables par séries du 1er septembre 51 au 1er septembre 65 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 33^% par année payable semi-annuel-lement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $250,000 \u201415 ans Année Capital 1er septembre 1951.x $13,500.00 1er septembre 1952.x 14,000.00 1er septembre 1953 .x 14,500.00 1er septembre 1954.x 15,000.00 1er septembre 1955.x 15,500.00 1er septembre 1956 '.x 16,000.00 1er septembre 1957.x 16,500.00 1er septembre 1958.x 17,000.00 1er septembre 1959 .: x 17,500.00 1er septembre 1960.x 18,000.00 Province of Quebec School Commission op Saint-Bernard (County of Abitibi-East) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Roland Charest, Secretary-treasurer, P.O.Box No.2, Sullivan, county of Abitibi-East, up to 8 o'clock in the evening, Thursday, the 2nd day of November, 1950, for the purchase of $250,000 of .bonds, of the School Commission of Saint-Bernard, county of Abitibi-East, dated the 1st of September, 1950, and redeemable serially from the 1st of September 1950 to the 1st of September 1965 inclusively, with interest at a rate not exceeding 33^% per annum, payable semi-annually the 1st of March and 1st of September of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $250,000 \u201415 years Year Capital September 1st, 1951.x $13,500.00 September 1st, 1952 .x 14,000.00 September 1st, 1953 .x 14,500.00 September 1st, 1954 .x 15,000.00 September 1st, 1955 .x 15,500.00 September 1st, 1956 .x 16,000.00 .September 1st, 1957 .x 16,500.00 September 1st, 1958 .x 17,000.00 September 1st, 1959 .x 17,500.00 September 1st, 1960 .x 18,000.00 2600 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U octobre 1960, Tome 82, N° Àl 1er septembre 1961 .3,500.00 1er septembre 1962 .3,500.00 1er septembre 1963 .3,500.00 1er septembre 1964 .3,500.00 1er septembre 1965 .78,500.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $155,291.20 accordé par le Secrétaire de la Province et payable en dix versements annuels de $15,529.12 seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Québec, à Montréal ou à Val d'Or.Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance de la commission scolaire Saint-Bernard qui sera tenue jeudi, le 2 novembre 1950, à 8 heures p.m., à l'école Saint-Bernard (Sullivan), Abitibi-Est.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sullivan (Comté de Abitibi-Est), ce 11 octobre 1950.Le Secrétaire-trésorier, ROLAND CHAREST, CP.2, 28538-o Sullivan, Abitibi-Est, P.Q.Province de Québec Commission scolaire catholique de la cité d'Alt vida Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Yvan Morrier secrétaire-trésorier, 274 rue Monte» Arvida, jusqu'à 7.30 heures p.m.lundi le 30 octobre 1950, pour Tachât de $575,000.d'obligations de la Commission scolaire catholique de la cité d'Arvida, datées du 1er décembre 1950 et remboursables par séries du 1er décembre 1951 au 1er décembre 1970 inclusivement avec intérêt à un taux n'excédant pas V/fflo Par année payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014*575,000\u201420 ans Année Capital 1er décembre 1951.$20,000 1er décembre 1952 .21,000 1er décembre 1953.22,000 1er décembre 1954 .23,000 1er décembre 1955 .24,000 1er décembre 1956 .25,000 1er décembre 1957 .;.26,000 1er décembre 1958 27,000 September 1st, 1961 .3,500.00 September 1st, 1962 .3,500.00 September 1st, 1963 .3,500.00 September 1st, 1964 .3,500.00 September 1st, 1965 .78,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $155,291.20 granted by the Provincial Secretary and payable in ten annual instalments of $15,-529.12 will be received and applied to the use of this loan.Capital and interest will be payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Quebec, Montreal or at Val d'Or.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1%-of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commission of Saint-Bernard, to be held on Thursday, the 2nd day of November, 1950, at 8 o'clock p.m., in the Saint-Bernard School (Sullivan), Abitibi-East.The commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Sullivan (County of Abitibi-East), this 11th day of October, 1950.ROLAND CHAREST, Secretary-Treasurer, P.O.Box 2, 28538 Sullivan, Abitibi-East, P.Q.Province of Quebec Catholic School Commission op the City op Arvida Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Yvan Morrier, secretary treasurer, 274 Moritz street, Arvida, up to 7.30 o'clock in the evening, Monday, the 30th day of October, 1950, for the purchase of $575,000 of bonds of the Catholic School Commission of the city of Arvida, dated the 1st of December, 1950, and redeemable serially from the 1st of December 1951 to the 1st of December, 1970 inclusively, with interest at a rate not exceeding 3%% pe1\" annum, payable semi-annually the- 1st of June and 1st of December of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of Redemption\u2014*676,000.00\u201420 years Year Capital December 1st, 1951.$20,000.00 December 1st, 1952 .21,000.00 December 1st, 1953 .22,000.00 December 1st, 1954 .23,000.00 December 1st, 1955 .24,000.00 December 1st, 1956.25,000.00 December 1st, 1957 .26,000.00 December 1st, 1958 .27,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October 11th, I960, Vol.82, No.11 2601 1er décembre 1959 .28,000 1er décembre 1960 .28,000 1er décembre 1961 .29,000 1er décembre 1962 .30,000 1er décembre 1963 .32,000 1er décembre 1964 .32,000 1er décembre 1965 .33,000 1er décembre 1966 .33,000 1er décembre 1967 .34,000 1er décembre 1968 .35,000 1er décembre 1969 .36,000 1er décembre 1970.37,000 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Arvida.Lcsditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941,' être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires qui sera tenue le lundi 30 octobre 1950 à 7.30 heures p.m., au bureau du secrétaire-trésorier, 274 rue Moritz à Arvida.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Daté à Arvida (Comté de Chicoutimi), ce 10 octobre 1950.Le Secrétaire-trésorier, YVAN MORBIER, 274, rue Moritz, Arvida, 2S537-0 comté de Chicoutimi.Ventes\u2014Loi de faillite December 1st, 1959 .28,000.00 December 1st, 1960 .28,000.00 December 1st, 1961 .29,000.00 December 1st, 1962 30,000.00 December 1st, 1963 .32,000.00 December 1st, 1964 .32,000.00 December 1st, 1965 .33,000.00 December 1st, 1966 .33,000.00 December 1st, 1967 .34,000.00 December 1st, 1968 .35,000.00 Deceml>er 1st, 1969 .36,000.00 December 1st, 1970 .37,000.00 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Arvida.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their maturity.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Commissioners to be held on Monday the 30th day of October, 1950, at 7.30 P.M., at the office of the Secretary-Treasurer, 274 Moritz street, Arvida.The commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Dated at Arvida, (County of Chicoutimi), this 10th day of October, 1950.YVAN MORRD3R, Secretary-Treasurer, 274, Moritz street, Arvida, 28537 county of Chicoutimi.Sales \u2014Bankcrupcy Act Avis de Vente Canada, Province de Québec, District de Montréal, N° 54, Cour Supérieure \"En faillite.\" Dans l'affaire de la faillite de: Gelas Robi-chaud, cédant autorisé; & Claude Perras, syndic.Avis est par les présentes donné que l'immeuble suivant, sera vendu à la folle enchère sur la tête de Louis Philippe De Grace, de Greenfield Park, enchérisseur défaillant, à savoir: \"Une propriété ayant front sur la rue Springfield, à Greenfiled Park, Province de Québec, connue et désignée comme étant la partie nord-ouest du lot numéro 47 de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent trente-neuf (239 Ptie N.O.47) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Lon-gueuil, mesurant 48 pieds de largeur sur l'Avenue Springfiled par 192 pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins.Borné ledit emplacement comme suit: en front, par L'Ave Springfield, en profondeur par une partie du lot N 239-52 dudit cadastre, un côté au nord-ouest par le lot numéro deux cent trente-neuf quarante-sept-un, dudit cadastre et au sud-est par une autre partie du lot N° 239-47 dudit cadastre, avec toutes les bâtisses dessus érigées Notice of Sale Canada, Province of Quebec, District of Montreal, No 54, Superior Court \"Sitting in Bankruptcy\".In the matter of the insolvency of: Gelas Robi-chaud, Authorized Assignor, & Claude Perras, trustee.Notice is hereby given that the following immovable will be sold for the false bidding of Louis Philippe De Grace, of Greenfield Park, false bidder, to wit: \"A property fronting on Springfield street, at Greenfield Park, Province of Quebec, known and designated as being the northwest part of lot number 47 of the official subdivision of original lot number two hundred and thirty-nine \"(239-N.W.Pt.47) on the official plan and in the book of reference for the parish of St-Antoine de Longueuil, measuring 48 feet in width on Springfield Avenue by 192 feet in depth, English measure, more or less.The said emplacement being bounded as follows: in front, by Springfield Avenue, in depth by a part of lot No.239-52 of said cadastre, on one side to the north-west by lot number two hundred and thirty-nine-forty seven-one, of said cadastre and on the southeast by another part of lot No.239-47 of said cadastre, with all the buildings thereon erected, 2602 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U octobre 1950, Tome 82, Nû 11 et plus spécialement une maison et ses dépendances portant le N° civique 18 Ave.Springfiled, à Greenfield Park, Province de Quebec.\" La vente aura lieu à la porte de l'Eglise paroissiale de Saint-Anastase, Greenfiled Park, Comté Chambly, à ONZE heures de l'avant-midi, MARDI le 7 NOVEMBRE 1950.Cette vente est faite conformément à un jugement rendu le 3 octobre 1950, par Beaudry & Leduc, Régistraire ordonnant la revente sur folle enchère de l'immeuble décrit ci-dessus.Conditions: comptant.En plus du d'adjudication, l'acquéreur devra payer les droits du gouvernement de 2%% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges, s'adresser au soussigné.Montréal, ce 10 octobre 1950.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de:.Perras & Perras, Syndics-Licenciés, 4 est, rue Notre-Dame, Montréal.28519-0 LOI DE FAILLITE Dans l'affaire de: Egide Deshaies, ville d'Artha-baska, cédant autorisé.Avis est par les présentes, donné que MARDI le QUATORZIÈME jour de NOVEMBRE 1950, à DIX heures de l'avant-midi à la porte de l'Eglise paroissiale, à Arthabaska, sera vendu par enchère publique l'immeuble suivant: Ce terrain ou emplacement situé côté Sud-Est de la rue Suzor, ci-devant rue de la Manufacture, en la ville d'Arthabaska, contenant cinquante-deux pieds (52) de front sur Cent vingt pieds (120) de profondeur, le tout plus ou moins, connu et désigne au cadastre officiel du village d'Arthabaskaville sous partie du numéro deux cent quarante-sept (P.247) ensemble avec toutes les bâtisses dessus érigées; borné en frtint au Nord-Ouest à la rue Suzor, en profondeur au Sud-Est à John Blanchet, d'un côté au Nord-Est à la rue Mailhiot et de l'autre côté au Sud-Ouest à Adrien Pouliot.Cette vente est faite en conformité à l'art.55 de la loi de faillite (1949) et aura l'effet du décret.Condition de vente: Argent comptant.Pour plus de renseignements s'adresser au soussigné, 10 octobre 1950.Le Syndic, B.FEENEY.Bureau : 4*2, rue St-Jean-Baptiste, * princeville, Que.28529-41-2-0 and in particular a house and its dependencies bearing civic No.18 Springfield Avenue, at Greenfiled Park, Province of Quebec.\" The sale will be held at the parochial church door of Saint-Anastase, Greenfield Park, county of Chambly, at ELEVEN o'clock in the forenoon, on TUESDAY, NOVEMBER 7,1950.This sale is made pursuant to a judgment rendered on October 3, 1950, by Beaudry & Leduc, Registrar, ordering the resale for false bidding of the immovable hereinabove described.Conditions: Cash.In addition to the adjudication price, the purchaser must pay the government dues of 2/^% according to Law.For further information and list of charges, apply to the undersigned.Montreal, October 10, 1950.\u2022 CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of: Perras & Perras, Licensed Trustes, 4 Notre-Dame Street East, Montreal.28519 BANKRUPTCY ACT In the matter of Egide Deshaies, town of Arthabaska, authorized assignor.Notice if hereby given that on TUESDAY, the FOURTEENTH day of 1st NOVEMBER 1950, at TEN o'clock in the forenoon at the pa-rochail church door, at Arthabaska will be sold at public auction the following immoveable: That piece of land or emplacement situate on the South-East side of Suzor street, formerly La Manufacture Street containing fifty two feet in front (52) by one hundred and twenty feet (120) in depth, more or less, and known and designated on the official cadastre for the Village of Arthabaskaville, as forming part of number two hundred and forty-seven (P.247), together with all the buildings thereon erected;, bounded infront to the North-West by Suzor Street, at the depth to the South-Wast by John Blanchet on the North-East Side by Mailhot Street and on the South-West side by Adrien Pouliot.Said sale is thus made pursuant to art.55 of the Bankruptcy Act (1949) and will have the effect of a Sheriff's sale.Conditions of sale: Cash.For further information, apply to, October 10, 1950.Office : 42, St-Jean-Baptiste, st., Princeville, Que.B.FEENEY, Trustee.28529-41-2-0 Vente par licitation Sale by Licitation Canada, Province de Québec, District de Hull, Cour Supérieure, N° 125.Ronald St-Laurent, demandeur vs René Emmanuel St-Laurent et al, défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Hull, dans le district de Hull, le 2e jour de septembre 1950, dans une cause dans laquelle: Ronald St-Laurent, gardien-commis, des cité et district de Hull, tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de son père, feu Joseph Canada, Province of Quebec, District of Hull, Superior Court, No.125.Ronald St-Laurent, plaintiff, vs René Emmanuel St-Laurent et Al, defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that under and by virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at Hull, m the district of Hull, on the 2nd day of September 1950, in a cause in which: Ronald St-Laurent, watchman and clerk of the city and district of Hull, personally as well as in his quality of heir to his father, the late QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lhth, I960, Vol.82, No.hi 2603 Octave St-Laurent, de son vivant des mômes lieux, est demander et René Emmanuel St-Laurent, de la cité de New-York dans l'état de New-York, l'un des États-Unis d'Amérique; Arsène St-Laurent, de la cité de Détroit, dans l'état de Michigan, l'un des États-Unis d'Amérique; Jeanne St-Laurent, épouse de J.-A.Major, pt ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, tous deux de la cité d'Ottawa, dans la province d'Ontario, et dame Marie-Ange Cyr, veuve de Octave Provin St-Laurent de l'endroit appelé Cyrville dans la province d'Ontario, tous tant personnellement qu'en leur qualité d'héritiers de leur père, ledit J.Octave St-Laurent, en son vivant des cité et district de Hull, sont défendeurs, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: Cette propriété connue et désignée comme étant partie de la moitié est du lot numéro soixante-quinze (75) du quartier trois (3) de la Cité de Hull, et du quart sud-est (^4 s.c.) du lot soixante-huit (68) du susdit quartier (3), aux plan et livre de renvoi officiels de ladite Cité de Hull;avec toutes les bâtisses y dessus érigées et ledit emplacement borné comme suit: au sud, par la rue St-Étienne; à l'est, par la rue St-Henri; au nord, par une autre partie dudit lot numéro soixante-huit (68); à l'ouest, partie par la moitié ouest dudit lot soixante-quinze (75) et partie par la moitié ouest dudit lot soixante-huit (68) ; L'immeuble ci-dessus désigné sera mis ù l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur le SIX NOVEMBRE 1950, Cour tenante, dans la salle d'audience du Palais de Justice de Hull, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite Cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Hull, le 30 septembre 1950.L'Avocat du demandeur, 28455-40-2-o RODRIGUE BÉDARD.Joseph Octave St-Laurent, in his lifetime of the same place, is plaintiff and René Emmanuel St-Laurent, of the city of New-York, in the state of New-York, one of the United States of America; Arsène St-Laurent of the city of Detroit, in the state of Michigan, one ofthe United States of America; Jeanne St-Laurent, wife of J.-A.Major and the latter to authorize his wife for the purposes of these presents, both of the city of Ottawa, in the province of Ontario; and dame Marie-Ange Cyr, widow of Octave Provin St-Laurent, of the place called Cyrville, in the province of Ontario, all personally as well as in their quality of heirs to their father, the said J.Octave St-Laurent, in his lifetime of the city and district of Hull, are defendants, ordering the licitation of certain immoveables described as follows, to wit: AU this piece of land being part of the cast half of lot number seventy-five (75) of ward three (3) of the city of Hull, and of the southeast quarter of lot number sixty-eight (68) of the said ward three (3), according to the official plan and book of reference of the said city of Hull; with all buildings thereon erected and the said property being bounded as follows: towards the south, by St-Étienne Street; towards the east, by St-Henri Street, towards the north, by another part of said lot number sixty-eight (68); towards the west, partly by the west-half of said lot number seventy-five (75) and partly by the west-half of said lot number sixty-eight (68); The above property as described will be put up to auction and adjudged to the last and highest bidder on the SIXTH day of NOVEMBER 1950, sitting the Court, in the Court Room of the Court House in the city of Hull, subject to the charges, clauses and conditions contained in the list of charges deposited in the office of the prothonotary of the said Court; and that any opposition to annul, to secure charges, or to withdraw, to be made to the said licitation, must be filed in .the office of the prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and that any opposition for payment must be filed within six days after the adjudication; and failing the parties to file such oppositions within the delays hereby limited, they will de foreclosed from so doing.Hull, September 30th, 1950.RODRIGUE BÉDARD, 28455-40-2-o Attorney for the plaintiff.VENTES PAR SHÊRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LAND and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.Fieri Facias Bonis et de Terris Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure\u2014District d'Arthabaska Superior Court \u2014 District of Arthabaska Arthabaska, ( T ANDRÉ MAILHOT, boucher- Arthabaska./ T ANDRE MAILHOT, butcher- à savoir: demandeur, vs JOSEPH NAPOLÉON COMEAU, défendeur S.J.PAUL VERMETTE, es-qualité de syndic et de curateur au délaissement.\"Un emplacement situé dans le Village de St-Martin, ayant front sur le Boulevard Labelle, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro troiscent quatre vingt trois (ptie N° 383) des plan et livre de renvoi officielle de la paroisse de St-Martin, mesurant environ cent soixante-quatorze et cinq dixième de pieds de largeur par quatre vingt treize pieds de profondeur sur une largeur de cent soixante cinq pieds du Nord au Sud et de la une profondeur de soixante-quinze pieds sur le reste de la profondeur, borné comme suit: En front a l'ouest par le Boulevard Labelle et des autres côtés par le résidu dudit lot, l'extrémité Nord de ce terrain se trouve a cent quinze pieds de la limite Sud de l'emplacement de monsieur Lachaine ou représentants; cet emplacement ci-dessus a été subdivisé et constitue maintenant les lots numéros 10 et 10a de la subdivision du lot 383 du cadastre de la paroisse de St-Martin.Pour être vendu, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Martin, le VINGT-SIX OCTOBRE prochain, à ONZE heures du matin.Le Shérif, CAISSE & HURTEAU.Bureau du Shérif, Montréal, 18 septembre 1950.28354-38-2-o [Première insertion: 23 septembre 1950] the north by Ernest Lebel, on the east by Ovila Dubé, on the south by the public road, on the west by Joseph Houle.The whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the church door of the parish of St-Pacôme, on TUESDAY, the FOURTEENTH day of the month of NOVEMBER, 1950, at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, .Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, October 10, 1950.28523-41-2 [First insertion: October 14, 1950] LABELLE Canada, Province of Quebec, Superior Court District of Labelle, j pAUL EMILE FORGET, No.2218 ] -t merchant, domiciled at Labelle, County of Labelle, plaintiff; vs ROSARIO BERGERON, domiciled at La Minerve, in the county of Labelle, defendant.Lots numbers 19-A 19-B of the sixth range of the official plan and book of reference for the township La Minerve, county and district of Labelle, with buildings thereon erected.To be sold at the parish church door of the village of La Minerve, on the FIFTEENTH day of NOVEMBER 1950, at TWO o'clock in the afternoon.ALFRED BOURDON, Sheriff's Office, Sheriff.Mont-Laurier, P.Q.28524-41-2 [First insertion: October 14, 1950] MONTREAL Fieri Facias de Terris C.S.District of Montreal Montreal, to wit: [ A EGÉDIUS GAGNON, No.286301 } plaintiff; vs JOSEPH NAPOLÉON COMEAU, defendant; J.PAUL VERMETTE, ès qualité of trustee and curator to the abandonment.\"An emplacement in the village of St.Martin, fronting on Labelle Boulevard, known and designated as forming part of lot number three hundred and eighty three (Pt.No.383) on the official plan and in the book of reference for the parish of St.Martin, measuring about one hundred and seventy-four feet and five tenths of a foot in width by ninety-three feet in depth by a width of one hundred and sixty-five feet from North to South and a depth of seventy-five feet on the rest of the depth, bounded as follows : In front, on the west, by Labelle Boulevard, and on the other sides by the residue of said lot, the northern extremity of said lot of land being one hundred and fifteen feet distant from the South limit of the emplacement of Mr.Lachaine or representatives; the above emplacement has been subdivided and now forms lots number 10 and 10a of the subdivision of lot 383 of the cadastre of the parish of St.Martin.To be sold at the parochial church door of the parish of St.Martin, on the TWENTY-SIXTH of OCTOBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal, September 18, 1950.28354-38-2 [First insertion: September 23, 1950] 2606 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1A octobre 1950, Tome 82, N° Il Fieri Facias de Bonis et de Terris C.S.\u2014District de Montréal Montréal, //CANADIAN ASBESTOS COM-à savoir: < PANY, demanderesse, vs AI-N° 281926 IMÊ RAYMOND, de la cité de Montréal, faisant affaires sous les nom et raison sociale de RAYMOND ASBESTOS INSULATION REG'D, défendeur.\"Un immeuble .situé dans la paroisse de St-Jo-seph, comté de Laval, portant les numéros 181-2-3 de la subdivision 96 (96-181, 182, 183) des plan et livre de renvoi de la paroisse de Rivière des Prairies et portant le numéro 9300 Boulevard des Italiens, coin Odinot, avec les bâtisses dessus érigées.\" Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le VINGT-SIXIÈME jour d'OCTO-BRE prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, .CAISSE & HURTEAU.Bureau du Shérif, Montréal, 18 septembre 1950.28353-38-2-0 [Première insertion: 23 septembre 1950] Fieri Facias de Bonis et de Terns C.S.District de Montréal Montréal, fT> AVARY BUILDERS SUPPLY à savoir : < CO.LTD., demanderesse, vs N° 288500 IH.MARCEL PROVOST, défendeur.Un lot de terre ayant front sur la rue Sherbrooke, dans la cité de Montréal, connu comme étant les Nos quatre cent soixante-neuf et quatre cent soixante-dix (469-470) de la subdivision officielle du lot originaire no trois cent quatre-vingt dix-huit (398) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Longue-Pointe, avec toutes les bâtisses dessus construites et dépendances.Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le DIX-SEPT NOVEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, CAISSE & HURTEAU.Bureau du Shérif, Montréal, 10 octobre 1950.28525-41-2-0 [Première insertion: 14 octobre 1950] QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: /TRONAT ROY, chirurgien-N° 61-101.dentiste, domicilié au (numéro 1556, Avenue des Pins, Sillery, comté de Québec, contre L'HONORABLE ANATOLE CARIGNAN, de Montréal, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Magloire Baillargeon, à savoir: La subdivision N° 247 (deux cent quarante-sept) du lot N° 511 (cinq cent onze) du cadastre officiel pour St-Roch Nord, maintenant quartier Limoilou, de la cité de Québec, étant un emplacement situé sur la 8ème Avenue, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Le mur de séparation de la propriété voisine, du côté nord-est étant mitoyen et dont le centre sert de division permanente et irrévocable entre les deux propriétés.Pour être vendue à mon bureau en la Cité de Québec, le TROISIEME jour de NOVEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, ' AIMÉ DION.Québec, 27 septembre 1950.28444-39-2-0 rPremière insertion: 30 septembre 1950] [Seconde insertion : 14 octobre 1950] Fieri Facias de Bonis et de Terris S.C.\u2014District of Montreal Montreal, (/CANADIAN ASBESTOS COM-towit: «JV^PANY, plaintiff, vs AIMÉ No.281926 (.RAYMOND, of the city of Montreal, carrying on business alone under the firm name and style of RAYMOND ASBESTOS INSULATION REG'D., defendant.\"An immoveable situated in the parish of St.Joseph, county of Laval, bearing numbers 181-2-3 of the subdivision 96 (96-181-182, 183) of the plan and book of reference of the parish of Rivière des Prairies and bearing the number 9300 of Boulevard des Italiens corner Odinot, with the buildings thereon erected.\" To be sold at my office, in the city of Montreal, on the TWENTY-SIXTH of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal, September 18th, 1950.28353-38-2 [First insertion: September 23, 1950] Fieri Facias de Bonis et de Terris S.C.District of Montreal Montreal, / T> AVARY BUILDERS SUPPLY to wit: { IV CO.LTD., plaintiff, vs II.No.288500 I MARCEL PROVOST, defendant.A lot of land fronting on Sherbrooke Street, in the city of Montreal, known as being Nos.four hundred and sixty-nine and four hundred and seventy (469-470) of the official subdivision of the original lot No.three hundred and ninety-eight (39§) on the official plan and in the book of reference for the parish of \"Longue-Pointe\"\u2014 with all the buildings thereon erected and dependencies.To be sold at my office in the city of Montreal, on the SEVENTEENTH of NOVEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal, October 10,1950.28525-41-2 [First insertion: October 14, 1950] QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit /TRONAT ROY, dental sur-No.61-101.geon, domiciled at numb- \\ er 1556, des Pins Avenue, Sillery, county of Quebec; against HONOURABLE ANATOLE CARIGNAN, of Montreal, in his quality of provisory administrator of the Estate of the late Magloire Baillargeon, to wit: Subdivision No.247 (two hundred and forty-seven) of lot No.511 (five hundred and eleven) of the official cadastre for St-Roch Nord, now Limoilou ward, of the city of Quebec, being au emplacement situate on 8th Avenue, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.The division wall of the neighbouring property, on the northeast sude, being \"mitoyen\" and the centre whereof serves as permanent and irrevocable diviison between the two properties.To be sold at my office in the city of Quebec, on the THIRD day of NOVEMBER nest, at TEN o'clock in the forenoon.AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, September 27, 1950.2844439-2 [First insertion: September 30, 1950] - [Second insertion : October 14, 1950] QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lkth, 1950, Vol.83, No.11 2607 Fieri Facias Cour de Magistrat Québec, à savoir: ( t EO VILLENEUVE, mar-N° 136-332 ] Li chand, de Charlesbourg, contre EUGENE LABONTE, de Charlesbourg, à savoir: La subdivision N° 32 (trente-deux) du lot N° 687 (six cent quatre-cingt-sept) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec, étant un emplacement situé dans la (lite paroisse, mesurant 65}^ pieds de front sur 199^ pieds sur une rue projetée, le tout plus ou moins, mesure anglaise, avec les bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de Charlesbourg, comté de Québec, le DIX-SEFriÈME jour de NOVEMBRE prochain, à DIX heures de l'avant-midi.¦ Le Shérif, AIME DION.Bureau du Shérif, Québec, 11 octobre 1950.28532-41-2-o [Première insertion: 14 octobre 1950] [Seconde insertion: 28 octobre 1950] RIMOUSKI F\\eri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 Rimouski Canada, (T S BRUGER & CO., Province de Québec, J \u2022L' LOUIS BRUGER, District de Rimouski, j marchand, de la cité N° 10641 V d'Outremont, district de Montréal, faisant affaires sous les nom et raison sociale de L.BRUGER & CO., demanderesse, vs RENÉ BRISSON, de la ville de Rimouski, défendeur.Partie de lot N° 188, étant un terrain de 53 pieds est-ouest sur 125 pieds de profondeur plus ou moins, M.A., au cadastre officiel de la paroisse de Rimouski, borné au nord au vendeur, à l'est à un chemin privé du vendeur, au sud au vendeur, à l'ouest à la Cie de Bois André avec droit de passage dans les deux chemins privés de vendeur, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Cette vente est sujette à une rente de $30.00 par année.Pour être vendu au bureau du shérif en la ville de Rimouski, le VINGT-TROIS OCTOBRE 1950, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, CHAS GARON.[Première insertion: 23 septembre 1950] SAGUENAY Cour Supérieure \\Bref d'exécution générale Canada, /CAISSE POPULAIRE Province de Québec, ) ^ DE ST-LOUIS ILE-District Saguenay, ) AUX-COUDRES, de-N° 7373 (manderessc, vs HENRI BOUCHARD, défendeur.Description: 1° La moitié indivisé de la partie Nord-Est du lot N° 121 du cadastre et livre de renvoie officiel, de la paroisse de l'Ile-aux-Coudres, comté de Charlevoix.2° Une maison d'habitation ou il demeure avec autre bâtisses dessus, qui a été construite, sur le terrain appartenant à la fabrique de St-Louis de rne-aux-Coudres.Pour être vendus à la porte de l'église de St-Louis de l'De-aux-Coudres Comté de Charlevoix, le VINGT-QUATRE OCTOBRE 1950, à DIX heures a.m.Le Shérif, PIERRE NÉRON.Bureau du Shérif, La Malbaie, 16 septembre 1950 .28356-38-2-o [Première insertion : 23 septembre 1950] Fieri Facias Magistrate's Court Quebec, to wit: j t EO VILLENEUVE, mer-No.136-332.) Lu chant, of Charlesbourg; against EUGENE LABONTE, of Charlesbourg, to wit : Subdivision No.32 (thirty-two) of lot No.687 (six hundred and eighty-seven) of the official cadastre for the parish of Charlesbourg, county of Quebec, being an emplacement situate in the said parish, measuring 65^ feet in front by 199^ feet on a proposed street, the whole more or less, English measure, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Charlesbourg, county of Quebec, on the SEVENTEENTH day of NOVEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.AIME DION, Sheriff.Sheriff's Office, Quebec, October 11, 1950.28532-41-2 [First insertion: October 14, 1950] [Second insertion: October 28, 1950] RIMOUSKI Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court\u2014Rimouski Canada, ( t S.BRUGER & CO., Province of Quebec,' ) *-» LOUIS BRUGER, District of Rimouski, ) merchant, of the city of No.10641 {Outremont, district of Montreal, carrying on business under the firm name and style of L.BRUGER & CO., plaintiff, vs RENÉ BRISSON, of the town of Rimouski, defendant.Part of lot No.188, being a lot of land of 53 feet east-west by 125 feet in depth, more or less, É.M., on the official cadastre for the parish of Rimouski, bounded on the north by the vendor, on the east by a private road of the vendor's, on the south by the vendor, on the west, by the \"Cie de Bois André\" with right of way in the two private roads of the vendor \u2014 with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.This sale is subject to a rent of $30 per annum.To be sold at the Sheriff's Office, in the Town of Rimouski, on the TWENTY-THTRD of OCTOBER, 1950, at TEN o'clock in the forenoon.CHAS GARON, Sheriff.- [First insertion: September 23, 1950] SAGUENAY Superior Court Writ of General Execution Canada, CAISSE POPULAIRE Province of Quebec, ) ^ DE ST-LOUIS ILE-District of Saguenay j aux-Coudres, plaintiff; vs No.7373 (HENRI BOUCHARD, defendant.Description: 1.The undivided half of the nordicast part of lot No.121 of the official cadastre and book of reference for the parish of Ilc-aux-Coudrqs, county of Charlevoix.2.A dwelling house where he lives, with other buildings which were built on the land belonging to the Fabrique of St-Louis de l'Ile aux-Coudres.To be sold at the church door of St-Louis de l'fle-aux-Coudres, county of Charlevoix, on the TWENTY-FOURTH day of OCTOBER, 1950, at TEN o'clock in the forenoon.PIERRE NÉRON, Sheriff.Sheriff's Office, LaMalbaie, September 16, 1950.28356-38-2 [First insertion: September 23, 1950] 2608 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Il octobre 1950, Tome 82, N° U Arrêtés en Conseil ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1096 Québec, le 4 octobre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil Concernant la Réserve de Chasse et de Pêche de Chibougamau.Attendu que les limites actuelles de la Réserve de chasse et de pêche de Chibougamau telles qu'établies par l'arrêté ministériel N° 1339, en date du 8 avril 1946, n'ont jamais été déterminées sur le terrain et que le relevé de ces limites sont très onéreux; Attendu que si les limites étaient constituées par des bornes naturelles telles que cours d'eau, lignes de hauteur, etc., la surveillance de la réserve serait plus facile et le gibier principalement l'orignal, serait mieux protégé.Vu le paragraphe 6 de l'article 65 du chapitre 153 des Statuts refondus de Québec 1941, Il est ordonné en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre de la Chasse et des Pêcheries: \u2014 Que l'arrêté ministériel numéro 1339, en date du 8 avril 1946, soit amendé et que les limites déterminées par cet arrêté ministériel soient annulées et remplacées par les suivantes: Tout le territoire à l'intérieur de la ligne décrite comme suit: \"Partant d'un point à l'intersection de la ligne extérieure nord-ouest du canton Dufferin avec la ligne entre les rangs III et IV du même canton; de là sud-est, suivant la ligne entre les rangs III et IV de Dufferin jusqu'à la ligne entre les lots 48 et.49 du rang IV de ce canton; de là sud-ouest, suivant la dite ligne entre les lots 48 et 49 des rangs IV, V, VI et VII de Dufferin jusqu'à la ligne extérieure sud-ouest du rang VII du dit canton; de là suivant un azimut 201° pour une distance d'environ six milles (6M.).jusqu'à une ligne en direction est-ouest; de là ouest, suivant la dite ligne et son prolongement à l'ouest, sur une distance d'environ dix-neuf milles et demi (19^M.) jusqu'au méridien 73° 15'; de là nord, suivant le dit méridien 73° 15' sur une distance d'environ cinq milles et demi (5^M-) jusqu'à la ligne extérieure sud du canton Béland; de là, ouest suivant la ligne extérieure sud des cantons Béland, Bibaud et Decazes, soit une distance d'environ vingt-trois milles et trois dixièmes (23.3M.) jusqu'à la ligne extérieure-est du terrain détenu en franc-alleu par la Brown Corporation, laquelle ligne est dans une direction générale nord-sud dans la partie sud-ouest du canton Decazes; de là, nord suivant la dite ligne extérieure-est du dit terrain détenu en franc-alleu, puis sud-ouest, puis dans une direction générale ouest, suivant la limite nord du dit subside de la Brown Corporation dans les cantons Marquette, Huard et Dubois, jusqu'à une ligne de direction générale nord-sud dans le canton Dubois et qui fait la séparation du subside d'avec les terrains de la Couronne; de là nord, suivant la dite ligne dans le canton Dubois jusqu'à la ligne entre les cantons Ventadour et Dubois; de là nord-ouest jusqu'à la ligne de hauteur des terres entre les bassins du Lac St-Jean et de la baie de James; de là, dans une direction générale nord-est suivant la dite ligne de hauteur des terres entre les Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1096 Quebec, October 4, 1950.Present: The Lieutenant-Governor In Council.Concerning the Chibougamau Hunting and Fishing Reserve.Whereas the actual limits of the Chibougamau hunting and fishing reserve as established by the Order in Council No.1339, bearing date the 8th day of April, 1946, were never determined on the ground and a survey of the said limits would be very costly; Whereas if the limits were established by the natural boundaries such as the watercourses, the hcigbt-of-land lines, etc., supervision of the reserve would be easier and the game, moose in particular, would be better protected.In view of paragraph 6 of section 65 of chapter 153 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, It is consequently ordained, upon the recommendation of the Minister of Game and Fisheries:\u2014 That Order in Council No.1339, dated April 8, 1946, be amended and that the limits determined by the said order in council be revoked and replaced by the following: All the territory within the line described as follows: \"Starting from a point of intersection of the northwest outline of the Dufferin township with the line between ranges III and IV of the same township; thence southeastward, following the line between ranges III and IV of Dufferin as far as the line between lots 48 and 49 of range IV of the said township; thence south westward, following the said line between lots 48 and 49 of ranges IV, V, VI and VII of Dufferin, as far as the southwest outline of range VII of the said township; thence following an azimut 201° for a distance of about six miles (6 m.) as far as a line in an east-west direction; thence westward, following the said line and its prolongation westward, for a distance of about nineteen and one half miles (193^ M.) as far as the meridian 73° 15'; thence northward, following the said 73° 15' meridian for a distance of about five and one half miles (5j^ M.) as far as the south outline of the township Béland; thence, westward, following the south outline of the townships Béland, Bibaud and Decazes, namely a distance of about twenty-three miles and three tenths of a mile (23.3M.), up to the east outline of the land held in freehold (franc-alleu) by the Brown Corporation, the said line is in a general north-south direction in the southwest part of the township Decazes; thence, northward, following the said east outline of the said land held in freehold (franc-alleu), then southwest, then in a general westerly direction, following the north limit of the said subsidy of the Brown Corporation in the townships Marquette, Huard and Dubois, as far as a line in a general north-south direction in the direction in the \"township Dubois 'and which forms the separation of the subsidy from the Crown Lands; thence northward, following the said line in the township Dubois, up to a line between the townships Ventadour and Dubois; thence northwestward up to the line of the hcight-of-land between the basins of Lake St.John and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lith, I960, Vol.82, No.il 2609 bassins de la baie de James et du Lac St-Jean jusqu'à la parallèle de latitude 50° 00'; de là, est, suivant la dite parallèle de latitude 50° 00' jusqu'à la rive gauche de la Rivière du Chef; de là, dans une direction générale sud-est, suivantla dite rive gauche de la Rivière du Chef jusqu'à son intersection avec la rive gauche de la Rivière Chamouchouane; de là, dans une direction générale sud-est, suivant la dite rive gauche de la Rivière Chamouchouane, jusqu'à son intersection avec la ligne extérieure sud-ouest du rang IV du canton Dumais; de là sud-est, en traversant la Rivière Chamouchouane jusqu'au point de départ.\" A.MORISSET, 28520-41-2-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSELL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1093 Québec, le 4 octobre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"C\" Concernant une prolongation du droit de prélèvement du Comité Paritaire de l'industrie de la fourrure, district de Québec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, district de Québec, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1129-C du 13 octobre 1919, soit prolongé jusqu'au 1er mars 1951, aux mêmes taux et conditions.A.MORISSET, 29535-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRETE EN CONSELL .CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1094 Québec, le 4 octobre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant le changement de nom de la partie contractante patronale, décret relatif à l'industrie de la construction et de la réparation mécanique dans la région de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), l'Association patronale de la Métallurgie a demandé d'être dorénavant traitée comme partie contractante de première part à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 973 du 3D juin 1948 et amendements, relatif à l'industrie de la construction et de la réparation mécanique dans la cité de Québec et le territoire compris dans un rayon de 50 milles de ses limites, en raison de la dissolution de \"La Régionale de Québec de l'Association Professionnelle des Industriels\", partie contractante de première part; Attendu que le Ministre du Travail a donné avis de son intention de recommander l'appro- of James Bay; thence, in a general north-east direction following the said line of height -of-land between the basins of James Bay and Lake St.John as far as the 50° 00' parallel of latitude; thence, eastward, following the said 50° 00' parallel of latitude as far as the left bank of the Rivière du Chef; thence, in a general south-cast direction following the said left bank of the Rivière du Chef as far as its intersection with the left bank of the Chamouchouane River; thence, in a general southeasterly direction, following the said left bank of the Chamouchouane River as far as its intersection with the southwest outline of range IV of the township Dumais; thence southeast and crossing the Chamouchouane River to the starting point.A.MORISSET, 28520-41-2 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1093 Quebec, October 4, 1950.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"C\" Concerning an extension of the right to levy of the Parity Committee of the Fur Industry, District of Quebec.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, That the right to levy of the Parity Committee of the Fur Industry, District of Quelle, authorized by a by-law approved by Order in Council number 1129-C of October 13, 1949, be extended until March 1, 1951, with the same rate and conditions.A.MORISSET, 28535-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1094 Quebec, October 4, 1950.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning a change of name of the contracting party of the first part, decree relating to the mechanical engineering industry in the district of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), \"L'Association patronale de la Métallurgie\" has requested to be henceforth treated an contracting party of the first part to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 973 of June 30, 1948, and amendments, relating to the mechanical engineering industry in the city of Quebec and the territory comprised in a radius of 50 miles from its limits, because of the dissolution of \"L'Association professionnelle des Industriels, Régionale de Québec\", contracting party of the first part; Whereas the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the appro- 2610 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U octobre I960, Tome 82, N° il bation de cette requête, dans la Gazette officielle de Québec, édition du 26 août 1950; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de ladite requête; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail : Que dans ledit décret, numéro 973, l'Assoia-tion patronale de la Métallurgie soit traitée comme partie contractante de première part et que son nom soit substitué à celui de l'Association Professionnelle des Industriels, Régionale de Québec.(Document \"A\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 28535-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1094 Québec, le 4 octobre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"C\" val of such request in the Quebec Official Gazette, issue of August 26, 1950; Whereas no objection has been made against the approval of the said request; ' It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That in the said decree, number 973, \"L'Association patronale de la Métallurgie\" be treated as contracting party of the first part, and that its name be substituted for that of \"L'Association professionnelle des Industriels, Régional-) de Québec\".(Document \"A\" annexed to the Order) A.MORISSET, 28535-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1094 Quebec, October 4, 1950.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"C.Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments to the decree relating à l'industrie des matériaux de construction to the building materials industry in the Prov-dans la province de Québec.ince of Quebec.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par la section 3 (industrie du marbre) du décret numéro 324 du 30 mars 1950, relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ladite section 3; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 2 septembre 1950; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 324, soit modifié comme suit: L'échelle de salaires, apparaissant à l'article II de cette section 3 est remplacée par la suivante : \"Métiers: Taux horaires Tailleur de marbre à la main.$ 1-38 Apprenti tailleur de marbre: 1ère année.0.94 2ème année.1.06 3ème année.1.16 \u2022tenir année.1.27 Préposé au fonctionnement de machines à carborundum.1.32 Tailleur à la machine.1.16 Apprenti préposé au fonctionnement, de machines à carborundum : 1er semestre.1.01 2ème semestre.1.06 3ème semestre.1.16 Polisseur à la main et à la machine .- 1.16 Apprenti polisseur: 1er trimestre.1.01 après trois mois.1.16 Mouleur de terrazzo.1.32 Préposé au compresseur.1.16 Ajusteur de scie.1.161 Aide et manoeuvre.0.85 Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by part 3 (marble industry) of the decree number 324 of March 30, 1950, relating to the building materials industry in the Province of Quebec, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said part 3; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of September 2, 1950; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 324, be amended as follows: The wage scale contained in section II of this part 3 is replaced by the following: Wage rates \"Trades: per hour Hand cutter.$1.38 Apprentice marble cutter: 1st year.0.94 2nd year.\u2022 1.06 3rd year.1.16 4th year.1.27 Carborundum machine operator.1.32 Machine cutter.1.16 Apprentice carborundum machine operator: 1st six months.1-01 2nd 'six months.1 \u2022 06 3rd six months.1.16 Hand and machine polisher.1.16 Apprentice polisher: 1st three months.1.01 After three months.116 Terrazzo caster.1-32 Compressorman.1.16 Saw setter.1.16 Helper and labourer.1.85 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October lkth, 1950, Vol.82, No.kl 2611 Préposé au fonctionnement des scies: 1er trimestre.1.01 après trois mois.1.16 Polisseur de face.1.16 Polisseur de bouts.1.16 Préposé aux grues.1.16 Gardien (par semaine).«.30.00' (Document \"C\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 28535-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1094 Sawyerman on gang saws: 1st three months.1.01 After three months.1.16 Bed rubber face.\".1.16 Bed rubber end.1.16 Craneman.1.16 Watchman (per week).30.00\" (Document \"C\" annexed to the Order) A.MORISSET, 28535-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1094 Québec, le 4 octobre 1950.Québec, October 4, 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-cn-Conseil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Section \"B\" Part \"B\" Concernant des modifications au décret rela- Concerning amendments of the decree relating tif à l'industrie et aux métiers de la construction to the construction industry and trades in the dans la région de Montréal.district of Montreal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation de certains amendements au dédret numéro 407 du 12 avril 1950, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 2 septembre 1950; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Minitre du Travail; Que ledit décret, numéro 407, soit modifié comme suit: 1° Les mots \"Poseur de lattes en bois ou en tout autre matériel\" apparaissant à l'échelle de salaires de l'article III, sont remplacés par les suivants: \"Poseur de lattes en\"vois\", \"rocklath\" \"gyproc\" et autres substituts, à.l'exception de la latte métallique\".2° Les taux de salaires minima pour les métiers ci-après mentionnés apparaissant à la même échelle de salaires, sont remplacés par les suivants: \"Poseur de marbre.$1.60 Polisseur de marbro à la main.1.27 Poseur de tuile.'.1.60 Poseur de terrazzo.'.1.60 Préposé aux machines à polir le terrazzo (humide).1.21 Préposé aux machines à polir le terrazzo (sec).\u2022.1.41\" 3° Les paragraphes \"g\" et \"À\" de l'article XIX sont remplacés par les suivants: \"g) Apprentis poseurs de marbre, tuile et terrazzo: 1ère année.SI.11 2ème année.1.11 3ème année.1 - 27 4ème année.1.41\" \"h) Apprentis polisseurs de terrazzo à sec: Premier trimestre.$1.41 Deuxième trimestre.1 27 Après six mois.141 Apprentis polisseurs de terrazzo humide: Premier trimestre.1.06 Après trois mois.1.21\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 28535-0 Greffier du Conseil Exécutif.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of amendments to the decree number 407 of April 12, 1950, relating to the construction industry and trades in the district of Montreal; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of September 2, 1950; Whereas the objections set forth have been considered in pursuance of the Act; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 407, be amended as follows: 1.The words \"Lather (wood and all other material)\" mentioned in the wage scale of section III, are replaced by the word \"Wood lath rocklath and gyproc layer and other substitutes excepting metal lath.\" 2.The minimum wage rates for the trades hereafter mentioned, mentioned in the same wage scale, are replaced by the following: \"Marblesetter.$1.60 Hand marble polisher.1.27 Tile setter.1.60 Terrazzo layer.1 ¦ 60 Terrazzo polishing machine operator (water polishing).1.21 Terrazzo polishing machine operator (dry).1.41*; 3.Subsections \"g\" and \"h\" of section XIX are replaced by the following: \"g) Apprentices in the trades of marble, tile and terrazzo setters: Istyear.$101 2nd year.1-H 3rd year.1-27 4th year.M1 \"h) Apprentices terrazzo polishing machine operator (dry) : 1st three months.$1.11 Second period of three months.1.27 After six months.\u2022 \u2022 \u2022 1-41 Apprentice terrazzo polishing machine operator (wet): 1st three months.2?»» After three month s.1.21' (Document \"B\" annexed to the Order) A.MORISSET, 28535-0 Clerk of the Executive Council. 2612 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, lk octobre 1960, Tome 82, N° kl ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1094 Québec, le 4 octobre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"D\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans la région de Sorel.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), une requête a été présentée à l'honorable Ministre du Travail par les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 1764 du 2 septembre 1938, relatif à l'industrie de la construction dans la région de Sorel, à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 26 août 1950; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 1764, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article IH est remplacé par lé suivant: \"ILL Taux de salaires minima: Pour les fins de tarification des salaires, la juridiction territoriale décrite au paragraphe \"b de l'article H est divisée en deux zones comme suit: Zone I: La cité de Sorel, le village de Saint-Joseph-de-Sorel et un rayon de six (6) milles de leurs limites.Zone II: Toute la juridiction territoriale à l'exception du territoire compris dans la zone I.a) Les taux minima de salaires sont les suivants: Métiers: Zones I II Briqueteur, plâtrier, maçon et finisseur de ciment .$1.40 $1.40 Charpentier-menuisier.1.15 1.00 Poseur de paravents, bois ou métal, chassis, fenêtres, divisions en acier.1.15 1.00 Peintre et tapissier.1.05 0 95 Peintre-aspergeur.125 1.10 Tireur de joints (gyproc).1.30 Plombier et mécanicien en tuyauterie: Entrepreneur (services personnels) .1.25 1.10 Compagnon.1 \u2022 15 1.00 Jeune compagnon, 1er semestre.1.05 0.85 Jeune compagnon, 2ème semestre 1.15 0.95 Ferblantier-couvreur.1.15 1.00 Électricien: Entrepreneur (services personnels).1.25 1.10 Compagnon.1.15 1.00 Mécaniciens de machines fixes ou portatives à vapeur.1.05 0.95 Chauffeur de bouilloires.,.0.90 0.85 ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1094 Quebec, October 4, 1950.Present: The Lieutenant Governor in Council.Pad \"Z>\" Concerning amendments to the decree relating to the construction industry in the district of Sorel.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), a request has been submitted to the Honourable Minister of Labour by the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 1764 of September 2, 1938, relating to the construction industry in the district of Sorel, for the purpose of amending the said decree and its amendments; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of August 26, 1950; Whereas no objection has been made against its approval; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1764, be amended as follows: 1.Subsection \"a\" of section III is replaced by the following: \"III.Minimum rates of wages: For the purpose of establishing rates of wages, the territorial jurisdiction described in subsection \"6\" of section II is divided into two zones as follows: Zone I: The city of Sorel, the village of St-Joseph de Sorel and a radius of six (6) miles from their limits.- Zone II: The entire territorial jurisdiction with the exception of the territory covered by zone I.a) The minimum rates of wages shall be as follows: Trades: Zones I II Bricklayer, plasterer, mason and cement finisher.$1.40 $1.40 Carpenter-joiner.1.15 1.00 Setter of screens (wood of metal) frame-work, window, steel partitions.1.15 1.00 Painter and paper hanger.1.05 0.95 Painter-sprinkler.1.25 1.10 Joint pointer (gyproc).1.30 Plumber and pipe mechanic: Contractor (personal services) .1.25 1.10 Journeyman.1.15 1.00 Junior journeyman-lst 6 months 1.05 0.85 Juniorjourneyman-2nd6months 1.15 0.95 Tinsmith-roofer.1.15 1.00 Electrician: Contractor (personal services).1.25 1.10 Journeyman.1.15 1.00 Steam stationary or portable engine-man.1.05 0.95 Boiler fireman.0.90 0.85 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October tyk, 1950, Vol.82, No.11 2613 Préposé aux malaxeurs à vapeur .1.10 1.00 Préposé aux grues à vapeur.1.15 1.05 Préposé aux grues à gazoline ou à l'électricité.1.15 1.05 Poseur de marbre.1.10 0.95 Poseur de terrazzo.1.10 0.95 Poseur de tuile.1.05 0.95 Opérateur de vibrateur de ciment.1.25 Paysagiste.0.90 0.80 Conducteur d'attelage.0.95 0.85 Travailleur de fer ornemental : Monteur.1.20 0.90 Aide.0.85 0.75 Forgeron en construction.1.20 Chauffeur de camion, transport général et remorquage.1.00 0.89 Conducteur de bulldozer.1.25 Journalier (ouvrier non qualifié) .0.80 0.70 Porteur d'oiseau.0.90 Poseur d'acier d'armature.1.00 Gardien à la semaine (72 heures par semaine).0.60 0.35 Charpentier-menuisier et?peintre travaillant pour un manufacturier de portes et chassis.1.05 0.9D 2° Le paragraphe \"/\" de l'article VII est remplacé par le suivant: \"/) Les taux de salaires payables aux apprentis sont les suivants: i.Dans la zone I: Pour tous les métiers requérant un apprentissage: » 1ère année.0.60 2ème année.0.70 3ème année .0.80 4ème année.0.90 ii.Dans la zone II: Salaires horaires Métiers: année \u2022 le 2'e 3e 4e Briquetcur.0.45 0.55 0.65 0.75 PhUrier, maçon, poseur de marbre, de tuile et de terrazzo.0.45 0.50 0.60 0.65 Charpentier-menuisier .0.40 0.50 0.60 0.70 Peintre.0.40 0.45 0.55 0.65 tapissier.0.35 0.40 0.45 0.50 Électricien.0.40 0.45 0.50 0.65 Mécanicien en tuyauterie 0.45 0.50 0.60 0.70 Ferblantier-couvreur .0.35 0.40 0.45 0.50 Charpentier-menuisier (à l'emploi de manufacturiers d'ouvertures) .0:35 0.40 0.45 0.50\" 3° Sont radiés de la liste des parties contractantes de première part, les employeurs suivants qui ont cessé de faire affaires comme entrepreneurs de l'industrie du bâtiment: MM.Augustin Desjardins, Pierre Lavallée, J.-A.Payette, Joachin Cournoyer, Charbonneau & Peloquin.\" 4° Sont acceptés comme parties contractantes de première part, les employeurs suivants: \"MM.Jean Marc Métivier, Lucien Charbonneau, Jean Paul Provencher, J.-A.Garceau, Jean Louis Charbonneau, Lalancette & Frères, Martin & Millette Enrg., Amable Parenteau, Robert Parenteau, Fernand Lefebvre (Royal Electric), Roma Gravel, Clovis Racicot, Raymond Gosselin, La Cie de Construction Universelle Ltée, Auguste Desjardins.\" (Document \"D\" annexé à l'arrêté) 28535-0 A.MORISSET, Greffier du Conseil Exécutif.Steam mixer operator.1.10 1.00 Steam crane operator.1.15 1.05 Electrical and gas crane operator.1.15 1.05 Marble setter.1.10 0.95 Terrazzo layer.1.10 0.95 Tile setter.1.05 0.95 Cement vibrator operator.1.25 Landscaper.0.90 0.80 Horse driver.0.95 0.85 Ornamental iron worker: Erector./.1.20 0.90 Helper.0.85 0.75 Construction blacksmith.1.20 Trucking, special transport and towing.1.00 0.80 Bulldozer operator.1.25 Common labourer.0.80 0.70 Hod carrier.0.90 Reinforcing steel layer.1.00 Watchman on a weekly basis (72 hou rs per week).0.60 0.35 Carpenter, joiner and painter working for a door and window-frame.manufacturer.1.05 0.90 2.Subsection \"/\" of section VII is replaced by the following: \"/) The rates of wages payable to apprentices shall be as follows: i.In zone I: For all trades requiring an apprenticeship: 1st year.0.60 2nd year.0.70 3rd year.*.0.80 4th year.0.90 ii.In zone II: Trades: Hourly rates year 1st 2nd 3rd 4th Bridklayer.'.0.45 0.55 0.65 0.75 Plasterer, mason, marble, tile and terrazzo layer 0.45 0.50 0.60 0.65 Carpenter-joiner.0.40 0.50 0.60 0.70 Painter.0.40 0.45 0.55 0.65 Wall-paper hanger.0.35 0.40 0.45 0.50 Electrician.0.40 0.45 0.50 0.65 Pipe mechanic.0.45 0.50 0.60 0.70 Tinsmith, roofer.0.35 0.40 0.45 0.50 Carpenter, joiner (employed by a door and window-frame manufacturer).0.35 0.40 0.45 0.50\" 3.The following employers, having ceased to operate as contractors of the building industry, are stricken off the list of contracting parties of the first part : Messrs Augustin Desjardins, Pierre Lavallée, J.-A.Payette, Joachim Cournoyer, Charbonneau & Poliquin.4.The following employers are accepted as contracting parties of the first part: Messrs Jean Marc Métivier, Lucien Charbonneau, Jean Paul Provencher, J.-A.Garneau, Jean Louis Charbonneau, Lalancette & Frères, Martin & Millette Enrg., Amable Parenteau, Robert Parenteau, Fernand Lefebvre (Royal Electric), Roma Gravel, Clovis Racicot, Raymond Gosselin, La Cie de Construction Universelle Ltée, Auguste Desjardins.(Document \"D\" annexed to the Order) A.MORISSET, 28535-0 Clerk'of the Executive Council. 2614 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, IL octobre 1950, Tome 82, N° kl Département du Travail Department of Labour Avis d'approbation de règlements Notice of Approval of By-Laws L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister Travail, donne avis par les présentes, conformé- of Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Ix>i de la convention provisions of the Collective Agreement Act collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amende- (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), ments), que certains règlements d'amendement that amending by-laws concerning the apprenti- concernant l'apprentissage et la qualification ceship and the qualification of employees, adopt- des salariés, adoptés par le Comité conjoint des ed by the Joint Committee of Barbers and Hair- barbiers et coiffeurs, juridiction de Québec, en dressers, Quebec Jurisdiction, dated September date du 5 septembre 1950, ont été approuvés par 5, 1950, have been approved by Order in Council l'arrêté en conseil numéro 1093 du 4 octobre 1950 number 1093 of October 4, 1950, part \"A\", (section \"A\").Pursuant to the said Order in Council, the En vertu dudit arrêté, l'article 19 actuel des present section 19 of the by-laws of the said règlements dudit Comité paritaire a été abrogé Parity Committee have been delated and the et remplacé par le suivant: following substituted therefor: \"19.Certificat de qualification: Conformément \"19.Certificate of competency: Pursuant to aux dispositions de la Loi, le Comité paritaire the provisions of the Act, the Parity Committee exige que tous les salariés assujettis au décret requires every employee governed by the decree numéro 3365 du 1er septembre 1944 et ses amende number 3365 of September 1, 1944,and amendments, voulant continuer à exercer les métiers ments, who wish to continue the practisc'of the de barbier et de coiffeur, possèdent leur certificat barber and hairdressing trade, to hold their de qualification et ce, dans toute la juridiction certificate of competency, and this, in the entire territoriale dudit décret.\" territorial jurisdiction of the said decree.\" Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Duputy-Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labours.Québec, le 14 octobre 1950.28536-o Quebec, October 14, 1950.28536-0 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT NOTICE OF APPROVAL OF BY-LAW L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister Travail, donne avis par les présentes, conformé- of Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Loi de la convention provisions of the Collective Agreement Act collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amende- (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), ments), que le règlement spécial ci-après mention- that the following special by-law .adopted by né, adopté par le Comité paritaire des métiers the Building Trades Parity Committee for St.de la construction pour les comtés de St-Hyaein- Hyacinthe, Bagot and Rouville counties, has the, Bagot et Rouville, a été approuvé par l'ar- been approved by Order in'Council number 1093 rêté en conseil numéro 1093 du 4 octobre 1950 of October 4, 1950 (part \"D) and that its prov- (section \"D\") et que ses dispositions ont été isions have been rendered obligatory in pursuance déclarées obligatoires en vertu de la Loi de la of the Collective Agreement Act: convention collective: \"Art.31.Tenue du registre: Conformément au \"Art.31.Keeping of a register: Pursuant to paragraphe \"g\" de l'article 20 de la Loi, le comité subsection \"g\" of section 20 of the Act, the Parity paritaire rend obligatoire pour tout employeur Committee renders obligatory for every profes- professionnel régi par le décret nuéinro 2678 sional employer governed by the decreenumber du 12 juillet 1940 et amendements, un système 2678 of July 12, 1940, and amendments, a system d'enregistrement de tout travail qu'il régit ou la of registration of all the work governed by the tenue d'un registre où sont indiqués les nom, decree or the keeping of a register giving the name prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, in full and address of all employees in his employ, sa qualification ou classification, l'heure précise their qualification or classification, the exact à laquelle le travail a été commencé, a été inter- time at which the work was begun, interrupted, rompu, repris et achevé chaque jour, la nature resumed and ceased each day, the nature of such de tel travail et le salaire payé, avec mention du work and the wages paid, with mention of the mode et de l'époque de paiement, ainsi que tous mode and period of payment, as well as all other autres renseignements jugés utiles à l'application particulars deemed useful for the enforcement of du décret.\" the decree.\" Le Sous-fflinistre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GERARD TREMBALY, Deputy-Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 14 octobre 1950.28536-o Quebec, October 14, 1950.28536-x AVIS DE PRÉLÈVEMENT NOTICE OF LEVY L'honorable Antonio Barrette, ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister Travail, donne avis par les présentes que le of Labour, hereby gives notice that the jBarbers Comité paritaire des barbiers et coiffeurs de la and Hairdressers Parity Committee, jurisdiction juridiction de Saint-Hyacinthe, établi en exécu- of Saint Hyacinthe, formed under decree No.tion du décret numéro 2683, du 9 octobre 1941, 2683, of October 9th, 1941, and amendments, et amendements, a été autorisé par règlement has been authorized by a by-law approved by approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1093, Order in Council No.1093 of October 4,1950, part du 4 octobre 1950, section \"B\", le tout, d'ac- \"B\", in conformity with the provisions of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, October llth, 1950, Vol.82, No.11 2615 cord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 11 octobre 1950 au 11 octobre 1951; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% des salaires fixes et pourcentages payés à leurs salariés./>) Les artisans régis par le décret doivent verser au Comité paritaire les sommes suivantes: Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned : par semaine Pour les artisans barbiers des zones I, II, III et IV.S0.16K Pour les artisans barbiers de toutes les autres zones .0.\\2% Pour les artisans coiffeurs et coiffeuses pour dames des zones I, II, III et IV 0.16^4 Pour les artisans coiffeurs et coiffeuses pour dames de toutes les autres zones.0.12J^ c) Les salariés régis par le décret doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.