Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 décembre 1950, samedi 9 (no 49)
[" Tomb 82, N6 40 3085 Vol.82, No.49 Drapeau de 1» province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Ceo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Ceo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 9 décembre 1950 Quebec, Saturday, December 9th, 1950 AVIS AUX INTÉRESSÉS NOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements Rules 1° Adresser toute correspondance à: l'Impri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme without prejudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale or documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-clasae, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 3086 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1960, Tome 86, N° 49 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la Publication de certains documents, à cause de leur >ngueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de Partiels 7 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).\u2022 Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres p'acés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RËDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will'be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.20439-1-52 Lettres patentes Anachemia Chemicals Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente o:tobre 1950, constituant en corporation: Samuel E.Schwisberg, avocat et conseil en loi du Roi, Cyril E.Schwisberg, avocat, tous deux de la cité d'Outremont, et Sonya Schneyer, ser rétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et commerçai\".ts de produits de la mer, de la ferme et de la foret; du papier et les produits du papier; des tissus, marchandises sèches et chaussures; articles de métal, de minerais, de cuir, verre et plastique, et produits chimiques, sous le nom de \"Anachemia Chemicals Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires, d'une valeur au pair de S100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Letters Patent Anachemia Chemicals Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of October, 1950, incorporating: SamuelE.Schwisberg, advocate and King's Counsel, Cyril E.Schwisberg, advocate, both of the City of Outremont, and Sonya Schneyer, secretary, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in products of the sea, farm and forest; paper and paper products; fabrics, dry goods and footwear; articles of metal, mineral, leather, glass and plastics and chemical products, under the name of \"Anachemia Chemicals Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 109 common shares of a par value of $100.each, and 300 preferred shares of a par value of $100.each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3087 Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the Company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le ^Dated at the office of the Attorney General, trente octobre 1950.this thirtieth day of October, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28914 L.DÉSILETS.28914-o Deputy Attorney General.Builders and Contractors Equipment, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du 2 novembre 1950, constituant en corporation: (Jaston Cartier, Raymond Dicaire, comptables, et Jeannette Cartier, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de l'outil-Ii>ge, la machinerie, les outils et instruments de toutes sortes servant à la construction, sous le nom de \"Builders and Contractors Equipment, Limited\" avec un capital de $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 390 rue Laurier ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.Chevalier Lingerie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du trente et un octobre 1950, constituant en corporation: Jeanne Chevalier, Blandine Chevalier, marchandes, et Camille Chevalier, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer toutes et chacune des industries de mercier, pelletier, bonnetier, couturier, gantier, chemisier, tailleur, confectionneur, chapelier, costumier, marchand de drap, de chaussures, de marchandises sèches, de valises, de bijouterie et de meubles, sous le nom de \"Chevalier Lingerie Inc.\", avec un capital de $40,000.divisé en 100 actions communes de $100 chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un octobre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914-0 L.DÉSILETS.Builders and Contractors Equipment, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris'-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the second day of November, 1950, incorporating: Gaston Cartier, Raymond Dicaire, accountants, and Jeannette Cartier, spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in construction equipment, machinery, tools and implements of all kinds, under the name of \"Builders and Contractors Equipment, Limited\", with a capital stock of $50,000.divided into 500 common shares of $100.each.The head office of the Company will be at 390, Laurier Street West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914-o Deputy Attorney General.Chevalier Lingerie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirty-first day of October, 1950, incorportaing: Jeanne Chevalier, Blandine Chevalier, merchants, and Camille Chevalier, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on all and any of the industries of haberdasher, furrier, hosier, seamster, glover, shirt-maker, tailor, outfitter, hatter, costumier, cloth merchant and dealer in footwear, dry-goods, luggage, jewellery and furniture, under the name of \"Chevalier Lingerie Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Compagnie de Construction de Cartierville .Inc.Cartierville Construction Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dés compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatre novembre 1950, constituant en corporation: Yvon Jasmin, Réal Marcoux, avocats Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secrétaires, Compagnie de Construction de Cartierville Inc.Cartierville Construction Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day of November, 1950, incorporating: Yvon Jasmin, Real Marcoux, advocates, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secretaries, all of the city 3088 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 tous des cité et district judiciaire de Montréal, et J.-Roger Marceau, commis, de St-Mathias, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Acquérir, construire, exploiter et disposer de propriétés immobilières et agir comme contractai r, sous-contracteur, sous le nom de \"Compagnie de Construction de Cartierville Inc\" \u2014 \"Cartierville Construction Company Inc.\", avec un capital de 82,000 divisé en 400 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cartierville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914-o L.DÉSILETS.Connolly Construction*Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept novembre 1950, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi du Roi, Joseph R.Hoffman, avocat, Jean McFar-lane, dactylo, tous de la cité de Montréal, Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et-de constructeurs, sous le nom de \"Connolly Construction Corp.\", avec un capital de $60,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1950.Ii'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.Côte St.Michel Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de' la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du deux novembre 1950, constituant en corporation: David Weissman, administrateur, Mariette St-Arnaud, June Kirlin et Mavisk Grant, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Acquérir par achat, négocier et disposer de propriétés immobilières ou intérêt en iceux, sous le nom de \"Côte St.Michel Holdings Ltd.\", avec un capital de $100,000, divisé en 800 actions provilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions ordinaires, d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.Frank Glode Ltée \u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date and judicial district of Montreal, and J.Roger Marceau,.clerk, of St-Mathias, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To acquire, build, operate and dispose of immovable properties and to act as contractor and sub-contractor, under the name of \"Compagnie de Construction de Cartierville-Inc.\" \u2014 \"Cartierville Construction Company Inc.\", with a capital stock of $2.000 divided into 400 shares of St each.The head office of the company will be at Cartierville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Connolly Construction Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of November, 1950, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel,- Joseph 11.Hoffman, advocate, Jean McFarlane, typist, all of the City of Montreal, Benjamin Robinson, advocate and King's Counsel, of the City of Westmount, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"Connolly Construction Corp.\", with a capital stock of $60,000: divided into 100 common, shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 cadi.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914-o Deputy Attorney General.Côte St.Michel Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of tlie Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, inconformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the second day of November, 1950, incorporating: David Weiss-man, executive, Mariette St-Arnaud, June Kirlin and Mavis Grant, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To acquire by purchase, deal with and dispose of real estate or interest therein, under the name of \"Cote St.Michel Holdings Ltd.\", with a capital stock of $100,000.divided into 800 preferred shares having a par value of $100.each, and 200 common shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914-0 Deputy Attorney General.Frank Glode Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1960, Vol.82, No.49 3089 du trente octobre 1950, constituant en corporation: Frank G Iode, camionneur, Claire Gaudreault ménagère, tous deux des cité et district judiciaire de Quél)ec, et Prudent Bernier, menuisier, de l'Islct, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants: Opérer un service de transport général, sous K> nom de \"Frank Glode Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Ix» siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente octobre 1950.L*Assistant-procureur général, 2S014-o L.DÉSILETS.Imprimerie Royale Ltée Royal Printing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéliec des lettres patentes, en date du sept novembre 1950, constituant en corporation: Charles Contant, imprimeur, Marc Contant, imprimeur, tous deux de Saint-Vincent-de-Paul, Ernest Bégin, imprimeur, Gérald Rousseau, comptable, et Roger Beau lieu, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de l'imprimerie, sous le nom de \"Imprimerie Royale Ltée\" \u2014 \"Royal Printing Ltd.\", avec un capital de $50,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 2S914-o L.DÉSILETS.day of October, 1950, incorporating: Frank Glode, carter, Claire Gaudreault, house-wife, both of the city and judicial district of Quebec, and Prudent Bernier, joiner, of ITslet, judicial district of Montmagny, for the following purposes: To operate a general transporation service, under the name of \"Frank Glode Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Imprimerie Royale Ltée Royal Printing Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of November, 1950, incorporating: Charles Contant, printer, Marc Contant; printer, both of Saint-Vincent-de-Paul, Ernest Begin, printer, Gerald Rousseau, accountant, and Roger Beau-lieu, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the printing business, under the name of \"Imprimerie Royale Ltée\" \u2014 \"Royal Printing Ltd.\", with a capital stock of $50,000 divided into 1,000 common shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Kcrbary Furniture Manufacturing Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dès compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du 2 novembre 1950, constituant en corporation: John Zinnicker, William Zinnickcr, Jacob Zinnicker, Charles Edward Jeary, Joseph-Bernard Hlais, dessinateurs de meubles, de Longueuil et Ralph Zinnicker, dessinateur de meubles, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, vendre des meubles de toutes sortes et tous autres produits du bois, sous le nom de \"Kerbary Furniture Manufacturing Company Limited\", avec un capital de $30,000, divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.La Compagnie de Construction et de Pavage de Hull Limitée (1950) Hull Construction and Paving Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Kerbary Furniture Manufacturing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1941, bearing date the second day of November, 1950, incorporating: John Zinnicker, William Zinnickcr, Jacob Zinnicker, Charles Edward Jeary, Joseph-Bernard Biais, furniture designers, of Longueuil, and Ralph Zinnicker, furniture designer, of Verdun, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture, sell furniture of all kinds and all other wood products, under the name of \"Kerbary Furniture Manufacturing Company Limited\", with a capital stock of $30,000.divided into 300 shares of $100 .each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914-o Deputy Attorney General.La Compagnie de Construction et de Pavage de Hull Limitée (1950) Hull Construction and Paving Company Limited Notice is hereby given that under Part I of tbe Quebec Companies Act, letters patent have heen issued by the Lieutenant-Governor of the 3090 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the thirteentli du treize novembre 1950, constituant en corpo- day of November, 1950, incorporating: Joseph ration: Joseph-E.Laflamme, entrepreneur en E.Laftamme, building contractor, Louis Laflam- construction, :Louis Laflamme, contre-maître, me foreman, and François Paul Laflamme, clerk et François-Paul Laflamme, commis-comptable, and accountant, all of the city and judicial district tous des cité et district judiciaire de Hull, pour of Hull, for the following purposes: les objets suivants: Exercer les opérations d'entrepreneurs géné- To carry on the business of general contractors, raux, sous le nom de \"La Compagnie de Cons- under the name of \"La Compagnie de Construe- truction et de Pavage de Hull Limitée (1950)\" \u2014 tion et de Pavage de Hull Limitée (1950)\" \u2014 Hull Construction and Paving Company Limi- \"Hull Construction and Paving Company Lim- ted\", avec un capital de $20,000.divisé en 2,000 ited\", with a capital stock of $20,000 divided into actions de $10 chacune.2,000 shares of $10 each.Le siège social de la compagnie sera à Hull, The head office of the company will be at district judiciaire de Hull.Hull, judicial district of Hull.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, treize novembre 1950.this thirteenth day of November, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28914-0 L.DÉSILETS.28914 Deputy Attorney General.Laflamme & Compagnie Limitée Laflamme & Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice, is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.Alfred Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date 276, S.R.Q., 1941, bearing date the sixth day of du six novembre 1950, constituant en corpora- November, 1950, incorporating: Joseph Henri tion: Joseph-Henri Laflamme, Andre Laflamme, Laflamme, André Laflamme, tailors, and Jules tailleurs, et Jules Lessard, tous des cité et district Lessard, accountant, all of the city_ and judicial de Chicoutimi, pour les objets suivants: district of Chicoutimi, for the following purposes: Exercer le commerce de vêtements pour horn- To deal in men's and women's clothing of all mes et pour dames, de toutes sortes, sous le kinds, under the name of \"Laflamme & Commun de \"Laflamme & Compagnie Limitée\", avec pagnie Limitée\", with a capital stock of $40,000 Un capital de $40,000 divisé en 400 actions de divided into 400 shares of $100 each.$100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au numéro The head office of the company will_ be at 227, rue Racine, Chicoutimi, district judiciaire No.227 Racine street, Chicoutimi, judicial dis- de Chicoutimi.trict of Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le six Dated at the office of the Attorney General, novembre 1950.this sixth day of November, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28914o L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.La Société d'Histoire d'Arthabaska La Société d'Histoire d'Arthabaska Incorporée Incorporée Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente octobre 1950, constituant en corporation sans capital-actions: M.l'abbé Henri Bernier, prêtre, curé, Elphège Labbé, marchand et maire, Thomas Michel, industriel et maire, Charles-Robert Garneau, notaire, et Hormisdas Gariépy, avocat et conseil du Roi, tous d'Arthabaska, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Propager le goût et l'étude de l'histoire en général, et favoriser la recherche et la conservation des matériaux pouvant servir à l'histoire, sous le nom de \"La Société d'Histoire d'Arthabaska Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $19,999.Le siège social de la corporation sera à Artha-baska, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le trente octobre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914-q L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of October, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: the Rev.abbé Henri Bernier, parish priest, Elphège Labbé, merchant and mayor, Thomas Michel, industrialist and mayor, Charles Robert Garneau, notary, and Hormisdas Gariépy, advocate and King's Counsel, all of Arthabaska, judicial district of Artha-baska, for the following purposes: To spread the taste and study of history in general, and to encourage resrarch and the conservation of material of historic value, under the name of \"La Société d'Histoire d'Arthabaska Incorporée\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $19,999.' The head office of the corporation will be at Arthabaska, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950.Vol.82, No.49 3091 Lightcraft Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date, du trente-et-un octobre 1950, constituant en corporation: David Goodman, Philip Fischel Vincbergj Jack Lighstone, avocats, et Yvonne Bélanger, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et généralement faire le commerce d'appareils électriques de toute description, sous le nom de \"Lightcraft Limited\", avec un capital de $75,000, divisé en 500 actions privilégiées, d'une valeur au pair de $100 chacune, et 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du burcai du Procureur général, le tie ite-et-un octobre 1950.'¦' L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.Lightcraft Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirty-first day of October, 1950, incorporating: David Goodman, Philip Fischel Vineberg, Jack Light-stone, advocates, and Yvonne Bélanger, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal generally in electrical appliances of every description, under the name of \"Lightcraft Limited\", with a capital stock of $75,000.divided into 500 preferred shares of a parvalue of $100.each, and 250 common shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirty-first day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28914-o Deputy Attorney General.L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Windsor (Québec) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit novembre 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Conrad Cliarland, marchand, Albert Paquette, papetier, Raymond Clouticr, contremaître, Philippe Bourque, marchand, et M.le Chanoine J.Arthur Lemay, curé, tous de Windsor, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Fonder, établir, organiser et maintenir en existence des terrains de jciïx, sous le nom \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Windsor (Québec)\".Le montant auquel sont limités les biens im-hilicrs que la corporation peut posséder, est de 8100,000.Le siège social de la corporation sera à Windsor, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le huit novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914-0 L.DÉSILETS.L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Windsor (Québec) Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the eighth day of November, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Conrad Char-land, merchant, Albert Paquette, paper-maker, Raymond Cloutier, foreman, Philippe Bourque, merchant, afîd the Rev.Canon J.Arthur Lemay, parish priest, all of Windsor, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To found, establish, organize and maintain in existence playgrounds, under the name of L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Windsor (Quebec)\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Windsor, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eightluday of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Osborne Street Garage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre octobre 1950, constituant en corporation: Theobald Plamondon, Joseph Lanza, chauffeurs de taxis, et Stanley Kandestin, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter et faire le commère de toutes sortes d'automobiles et de véhicules moteurs?opérer des garages, sous le nom de \"Osborne Street Garage Inc.\", avec un capital de $99,000, divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune et 590 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre octobre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.Osborne Street Garage Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of October, 1950, incorporating: Theobald Plamondon, Joseph Lanza, taxi operators, and Stanley Kandestin, advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To purchase, and deal in all sorts of automobile and motor vehicles; to operate garages, under the name of \"Osborne Street Garage Inc.\", with a capital stock of $99,000.divided into 400 preferred shares of $100.each, and 590 common shares of $100.each.The head office of.the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28914-0 Deputy Attorney General. 3092 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1960, Tome 82, N° 49 R.Bissonnette Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du sept novembre 1950, constituant en corporation: Pauline Cabana, Hélène Hussard, sténographes, de la cité de Montréal, et Martine Ranger, sténographe, de L'Abord-à-Plouffe, toutes du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de chaussures de toutes sortes, et généralement le commerce de cuir, caoutchouc, plastic et leurs produits et sous-produits, sous le nom de \"R.Bissonnette Ltée\", avec un capital de 850,000 divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur générale, le sept novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914-0 L.DÉSILETS.Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatre novembre, 1950, constituant en corporation: Pierre Barrette, avocat, Cécile Carcan, et Paule Lamontagne, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épicier et de boucher, sous le nom de \"Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatre novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914-o L.DÉSILETS.R.Bissonnette Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-.Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of November, 1950, incorporating: Pauline Cabana, Hélène Hussard,.stenographers, of the city of Montreal, and Martine Ranger, stenographer, of L'Abord-à-Plouffe, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in footwear of all kinds, and deal generally in leather, rubber, plastic and their products and by-products, under the name of \"R.Bissonnette Ltée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The number of shareholders of the company will l>e limited to twenty; The head office of the company will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quel>ec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quelle, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day of November, 1950, incorporating: Pierre Barrette, advocate, Cécile Careau, and Paul Lamontagne, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of grocer and butcher, under the name of \"Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914 Deputy Attorney General.Select Converters Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première., partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente-et-un octobre 1950, constituant en corporation: Reuben Spector, Benjamin Schector, et Moses Moscovitch, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et négocier toutes sortes de vêtements et accessoires, sous le nom de \"Select Converters ters Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 150 actions privilégiées de $100 chacune èt 2,500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente-et-un octobre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.Select Converters Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of October, 1950, incorporating: Reuben Spector, Benjamin Schector and Moses Moscovitch, advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in all kinds of wearing apparel and accessories, under the name of \"Select Converters Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 150 preferred shares of $100 each, and, 2,500 common shares of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirty-first day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28914-0 Deputy Attorney General./ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1960, Vol 82, No.49 3093 The Mailman Foundation (Quebec) Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du deux novembre 1950, constituant en corporation sans capital actions: Abraham L.Mailman, administrateur d'affaires, de la cité de Montréal, Philip Fischel Vincberg, avocat, de la cité de Westmount, tous deux du district judiciaire de Montreal, Joseph L.Mailman, Otto E.Kraus, administrateurs d'affaires, Harry Alpern, comptable, tous de la cité de New York, État de New York, un des États Unis d'Amérique, pour les objets suivants: Établir, maintenir, assister et contribuer aux oeuvres philantropique et/ou de bienfaisance, ct/ou de charité de toutes sortes et de toute nature, sous le nom de \"The Mailman Foundation (Quebec) Inc.\".Le montant auquel sera limité la valeur des Itiens immobiliers que la corporation pourra posséder est de $3,000,000.Le siège social de la corporation sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.The Right-Made Garment Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres-patentes en date du deux novembre 1950, constituant en corporation: Norman Genser, Sydney Phillips, avocats, et Rose-Marie Bourgoing, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer, négocier et faire le commerce de costumes et bardes de tous genres sous le nom de \"The Right-Made Garment Limited\", avec nu capital de 810,000, divisé en 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune, et 1,000 actions ordinaires, d'une valeur au pair «le SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal, Daté du bureau du Procureur général, le le deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28914 L.DÉSILETS.The Mailman Foundation (Quebec) Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the second day of November, 1950, incorporating without share capital: Abraham L.Mailman, business executive, of the City of Montreal, Philip Fischel Vineberg, advocate, of the City of Westmount, both of the Judicial District of Montreal, Joseph L.Mailman, Otto E.Kraus, business executives, Harry Alpern, accountant, all of the City of New York, State of New York, one of the United States of America, for the following purposes: To establish, maintain, assist and contribute to philanthropic and/or benevolent and/or charitable endeavours of any kind and nature, under the name of \"The Mailman Foundation (Quebec) Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is 83,000,000.The head office of the Corporation will be in the City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914-0 Deputy Attorney General.The Right-Made Garment Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of November, 1950, incorporating: Norman Genser, Sydney Phillips, advocates, and Rose-Marie Bourgoing, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in and with suits and apparel of all kinds, under the name of \"The Right-Made Garment Limited\", with a capital stock of $40,-000 divided into 390 preferred shares having a par value of $100.each, and 1,000 common shares having a par value of $1.each.¦ The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28914-0 Deputy-Attorney General.United Warehouse Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du deux novembre 1950, constituant en corporation: Abraham Harold Crestohl, gérant, Dame Riva Shatsky, secrétaire, tous deux de la cité d'Outre-mont, et Dame Ruth Fleischer, épouse séparée de biens de Frcd Tanner, en vertu des lois de l'Autriche, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses diverses branches, le commerce de la mise en dépôt et l'entreposage, United Warehouse Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the second day of November, 1950, incorporating: Abraham Harold Crestohl, manager, Dame Riva Bernice Shatsky, secretary, both of the City of Outremont, and Dame Ruth Fleischer, wife separate as to property of Fred Tanner, in virtue of the laws of Austria, secretary, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of warehousing and storage in all its several branches, under the name 3094 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° Jfl sous le nom de \"United Warehouse Ltd.\", avec of \"United Warehouse Ltd.\", with a capital stock un capital de $250,000, divisé en 2,400 actions of $250,000 divided into 2,400 preferred shares privilégiées de $100 chacune et 1,000 actions ordi- of $100.each, and 1,000 common shares of Si0.naires de $10 chacune.each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the Company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, Judidial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le deux Dated at the office of the Attorney General, novembre 1950.this second day of November, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28914 L.DÉSILETS, 28914-0 Deputy Attorney General.Lettres patentes annulées Avis est donné que, par jugement rendu à Montréal, le 29ème jour d'octobre 1948, par l'honorable juge E.Fabre-Surveyer, l'un des juges de la Cour Supérieure dans et pour le district judiciaire de Montréal, lequel jugement fut confirmé par le jugement de la Cour du Banc du Roi (en appel) le 23 octobre 1950, l'annulation des lettres patentes de la compagnie \"Du-luth Sporting Club Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes émises sous le grand sceau de la province de Québec, le neuvième jour d'octobre 1934, en vertu de la Loi des compagnies de Québec, a été décrétée, et ce, conformément aux dispositions de l'article 231 de ladite loi.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour-de décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28933-0 L.DÉSILETS.Letters Patent Annuled Notice is hereby given, that by a judgment rendered at Montreal, on the 29th day of October, 1948, by the Honourable Justice E.Fabre-Surveyer, one of the judges of the Superior Court in and for the judicial district of Mont-treal, which said judgment was confirmed by a judgment of the Court of King's Bench (in appeal) on the 23rd day of October, 1950, the cancellation of the letters patent of the company \"Duluth Sporting Club Inc.\", incorporated by letters patent issued under the Great Seal of the Province of Quebec, on the ninth day of October, 1934, under the Quebec Companies' Act, was ordered and such, in conformity with the provisions of section 231 of the said Act.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28933 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Lady Dundee Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi ties compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du trente octobre 1950, à la compagnie \"Valcourt Textiles Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 août 1950, changeant son nom en celui de \"Lady Dundee Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le trente octobre 1950.L'Assistant-procureur général, 28954 L.DÉSILETS.Lady Dundee Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the thirtieth day of October, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Valcourt Textiles Limited\", incorporated by letters patent dated the eighth day of August, 1950, changing its name into that of \"Lady Dundee Inc.\" Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28954-0 Deputy Attorney General.L.Deniers et Cie Limitée L.Demers and Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 novembre 1950, à la compagnie \"Le Magasin du Jardinier (Limitée)\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5 août 1939, changeant son nom en celui de \"L.Demers et Cie Limitée\" \u2014 \"L.Demers and Co.Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 14 novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28954-0 L.DÉSUETS.L.Demers et Cie Limitée L.Demers and Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the fourteenth day of November, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Le Magasin du Jardinier (Limitée)\", incorporated by letters patent dated the fifth day of August, 1939, changing its name into that of \"L.Demers et Cie Limitée\" \u2014 \"L.Demers and Co.Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28954 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol 82, No.49 3095 Merrill Chain Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du six novembre 1950, à la compagnie \"The Canadian Meiritt Chain Ltd.\" constituée en corporation par lettres patentes datées du quatorze septembre 1950, changeant son nom en celui de \"Merritt Chain Co.Ltd.Daté du bureau du Procureur général, le six novembre 1950.L'Assistant-procurcui général, 28954 L.DÉSILETS.Merritt Chain Co.Ltd.Notice is hereby given that under Paît I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the sixth day of November, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The Canadian Merritt Chain Ltd.\", incorporated by letters patent dated the fourteenth day of September, 1950, changing its name into that of \"Merritt Chain Co.Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28954-o Deputy Attorney General.Northeastern Development Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la première paitie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, «le ladite Loi, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt-cinq octobre 1950, à la compagnie \"Second Gaspé Oil Ventures Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), constituée en corporation en vertu de la Loi «les compagnies, minières de Québec, par lettres patentes en date du 21 mars 1946, changeant son nom en celui de \"Northeastern Development Limited\" (Libre de responsabilité personnelle).Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq octobre 1950.L'Assistant-procureur \"général, 28954 L.DÉSILETS.St.Donat Country Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de' la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du vingt novembre 1950, à la compagnie \"Lac Ouareau Country Homes Ltd.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du vingt-ct-un novembre 1947, changeant son nom en celui de \"St.Donat Country Club Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1.950.L'Assistant-procureur général, 28954 L.DÉSILETS.Ste.Rose Cleaners and Laundercrs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du quatorze novembre 1950, à la compagnie \"Laval Ste-Rose Limitée\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 février 1948, changeant son nom en celui de \"Ste.Rose Cleaners and Launderers Ltd\".Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28954 L.DÉSILETS.Victoria Export Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Northeastern Development Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that binder Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-fifth day of October, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Second Gaspé Oil Ventures Limited\" (No personal liability), incorporated under the Quebec Mining Companies Act by letters patent dated March 21st, 1946, changing its name to that of \"Northeastern Development Limited (No Peronal Liability)\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of October, 1950.L.DÉSILETS, 28954-0 Deputy Attorney General.St.Donat Country Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the twentieth day of November, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Lac Ouareau Country Homes Ltd.\", incorporated by letters patent dated the twenty-first day of November, 1947, changing its name into that of \"St.Donat Country Club Inc.\" Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28954-o Deputy Attorney General.Ste.Rose Cleaners and Launderers Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of November, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Laval Ste-Rose Limitée\", incorporated by letters patent dated the twentieth of February, 1948, changing its name into that of \"Ste.Rose Cleaners and Launderers Ltd.\" Dated at the-office of the Attorney General, this 14th day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28954-o Deputy Attorney General.Victoria Export Inc.Notice is hereby given, that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the sixth day of 3096 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 novembre 1950, à la compagnie \"Renaissance Export Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 décembre 1945, changeant son nom en celui de \"Victoria Export Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 6 novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28954-0 L.DÉSILETS.November, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Renaissance Export Inc.\", incorporated by letters patent dated the twelfth day of December, 1945, changing its name into that of \"Victoria Export Inc.\" Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28954 Deputy Attorney General.Actions en séparation ne biens Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 293 355.Dame Maria Dasewicz, épouse commune en biens de Léon Leshchynski, tailleur, tous deux résidant et domiciliés dans les cité et disrict de Montréal, demanderesse, vs Léon Leshchynski, sud it, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, ce jour.Montréal, ce 30 novembre 1950.L'Avocat de la demanderesse, GÉRARD RAYMOND, 276 ouest, rue St-Jacques, 28918-o Montréal.Canada, Province de Québec, District de Montréal.Cour Supérieure, N° 292908.Dame Louise Matz, épouse en communauté de biens de John Hell man, de Mlle Lasalle, district de Montréal, cordonnier, demanderesse; vs John Hcll-man, époux de la demanderesse, de Ville Lasalle, district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée dans la présente cause le 15ème jour de novembre 1950.% Montréal, le 28 novembre 1950.Les Procureurs de la demanderesse, MERGLER & MERGLER, 637 rue Craig ouest, 28919 Montréal, Québec.Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour supérieure, No.293369.Dame Thérèse Bibcau, épouse commune en biens de Frank Roy, hotel lier, tous deux des cité et district de Montréal, demanderesse vs Frank Roy, hôtellier, des cité et district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 30 novembre 1950.Montréal, le 30 novembre 1950.Le Procureur de la demanderesse, 2S956-0 PAUL LEVESQUE.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1316 Québec, 30 novembre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Section \"F\" Concernant une modification au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Actions for separation as to property Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.293 355.Dame Maria Dasewicz, wife common as to properly of Leon Leshchynski, taylor, of the City and District of Montreal, plaintiff, vs Leon Leshchynski, aforesaid, defendant.An action in separation of property has been duly taken in this case, this day.Montreal, November 30th 1950.GÉRARD RAYMOND, Attorney for plaintiff, 276 St.James St., West, 28918-o Montreal.Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.292908.Dame Louise Matz, wife common as to property of John Hcllman, of Ville LaSallc, District of Montreal, shoemaker, plaintiff, vs John Hell-man, husband of plaintiff, of Ville LaSaIlc,Dis-trict of Montreal, shoemaker, defendant.An action in separation of property has been instituted in this present cause on the 15th day of November, 1950.Montreal, November 28th, 1950.MERGLER & MERGLER, Attorneys for plaintiff, 637 Craig Street West, 28919-o Montreal, Quebec.Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.293369.Dame Thérèse Bibeau, wife common as to property of Frank Roy, innkeeper, both of the city and district of Montreal, Plaintiff vs Frank Roy, innkeeper, of the city and district of Montreal, defendant.An action in separation as to property has been institued in this case on November 30th, 1950.Montreal, le 30 novembre 1950.PAUL LEVESQUE, 28956-0 Attorney for plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1316 Quebec, November 30, 1950 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"F\" Concerning an amendment to the decree relating to the construction industry and trades in the district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3097 Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par l'article XVI (industrie des ascenseurs) du décret numéro 407 du 12 avril 1950, relatif à l'industrie cl aux métiers de la construction dans la région de Montréal, ont présenté au Ministre «lu Travail Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 28 octobre 1950; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; ii, est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 407, soit modifié comme suit: Le sous-paragraphe \"a\" du paragraphe \"9\" «le l'article XVI est remplacé par le suivant: \"a) Région de Montréal: Mécanicien.S 1.75 Aide.1.23\" (Document \"F\" annexé à l'arrêté) * A.MORISSET, 28944-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1316 Québec, le 30 novembre 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conscil.Section '*/)\" Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les comtés de Chicoutimi, Lac St-Jean et Robe r val.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers «le barbier, coiffeur et coiffeuse dans les comtés de Chicoutimi, Lac St-Jcan et Roberval, rendue obligatoire par le décret numéro 2684 du 9 octobre 1941, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 30 septembre 1950: Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 2684, soit modifié comme suit: 10 Le paragraphe \"a\" de l'article IV est remplacé par le suivant: \"a) Pour les barbiers, apprentis et compagnons, la durée des heures de travail est répartie comme suit: 1.Dans le comté de Chicoutimi, sauf pour la cité d'Arvida et la Baie des Ha ! Ha !: Le lundi: 8.00 a.m.à 12.00 a.m.Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by section XVI (elevator industry) of the «lecrce num!>er 407 of April 12, 1950, relating to the construction industry and trades in the district of Montreal, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said «lecrce; Whereas the said request has been published in the Quebec Officielle Gazette, issue of October 28, 1950; Whereas no objection has been made to its approval; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 407, be amended as follows: Paragraph \"a\" of subsection \"9\" of section XVI is replaced by the following: \"a) Montreal district: Mechanic.$1.75 Helper.1.23\" (Document \"F\" annexed to the Order) A.MORISSET, 28944-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1316 Quebec, November 30, 1950.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"D\" Concerning amendments to the decree relating to the barber and hairdressing tiades in the counties of Chicoutimi, Lake St.John and Roberval.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the counties of Chicoutimi, Lake St.John and Roberval, rendered obligatory by the decree number 2684 of October 9, 1941, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree and its amendments; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of September 30, 1950; Whereas the objections set forth have been considered in pursuance of the Act; It is ordained, therefore, upon the ¦ recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 2684, be amended as follows: -i.Subsection \"a\" of section IV is replaced by the following: \"a) For barbers, apprentices and journeymen, the duration of working hours is distributed as follows: 1.In the county of Chicoutimi, excepting the city of Arvida and La Baie des Ha ! Ha !: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 a.m.Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m. 3098 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Le samedi et la veille des fêtes chômées, ainsi que les deux jours précédant Noël et le jour de l'An: 8.00 a.m.à 10.00 p.m.2.Dans la cité d'Arvida: Le lundi: 8.00 a.m.à 12.00 a.m.Les mardi, mercredi, jeudi et samedi: 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi, la veille des fêtes chômées, ainsi que les deux jours précédant Noël et le jour de l'An: 8.00 a.m.à 10.00 p.m.3.Dans la Baie des Ha ! Ha !: Le lundi: 8.00 a.m.à 12.00 a.m.Les mardi, mercredi et jeudi: 8.00 p.m.ù 6.00 p.m.Les vendredi et samedi: 8.00 a.m.à 8.00 p.m.La veille des fêtes chômées ainsi que les deux jours précédant Noël et le jour de l'An: 8.00 a.m.à 10.00 p.m.4.Dans le comté de Lac St-Jean: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi: 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi: 8.00 a.m.à 8.00 p.m.Le samedi et la veille des fêtes chômées: 8.00 a.m.à 10.00 p.m.L'avant-veille de Noël et du jour de l'An: 8.00 a.m.à 9.00 p.m.5.Dans le comté de Roberval: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi: 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi: 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Le samedi et la veille des fêtes chômées: 8.00\"a.m.à 10.00 p.m.Toutefois, à partir du 15 décembre jusqu'au 31 décembre inclusivement, les heures de travail sont de 8.00 a.m.à 10.00 d.m.\" 2° Le paragraphe \"/\" de l'article IV est radié 3^ Le paragraphe \"aa\" suivant est ajouté à la suite du paragraphe \"a\" de l'article VI: v \"aa) Pour le comté de Chicoutimi exclusivement et nonobstant les dispositions du paragraphe \"a\" du présent article, les prix minima des services des barbiers et coiffeurs pour hommes pour la coupe des cheveux et de la barbe, sont les suivants : \"Cheveux pour adultes des deux sexes: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.S0.60 Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées ainsi que les deux jours précédant Noël et le jour de l'An.0.65 Cheveux pour enfants de 'moins de 14 ans des deux sexes: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.40 Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées ainsi que les deux jours précédent Noël et le jour de l'An.0.55 Cheveux en brosse et demi-brosse et \"Hollywood\": Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.90 Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées ainsi que les deux jours précédant Noël et le jour de l'An.1.00 .Barbe ordinaire.0.30 Barbe coupée aux ciseaux.0.40\" (Document \"D\" annexé à l'arrêté).A.MORISSET, 28944-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1316 Québec, le 30 novembre 1950.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil Section \"E\" Saturday and holiday eves, and the two days before Christmas and New Year's Day: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.2.In the city of Arvida: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 a.m.Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturdav: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and holiday eves, and the two days before Christmas and New Year's Day: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.3.La Baie des Ha ! Ha ! Monday: 8.00 a.m.to 12.00 a.m.Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and Saturday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.Holidays eves and the two days before Christmas and New Year's Day: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.4.In the county of Lake St.John : Monday, Tuesday, Wednesday and Thursdav: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.The second day before Christmas and New Year's Day: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.5.In the county of Roberval: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursdav: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.From December 15 to December 31 inclusive, the working hours are from 8.00 a.m.to 10.00 p.m.\" 2.Subsection \"/\" of section IV is deleted.3.The following subsection \"aa\" is added after subsection \"a\" of section VI: \"aa) For the county of Chicoutimi exclusively, and notwithstanding the provisions of subsection \"a\" of the present section, the minimum prices of barbers' and men's hairdressers' service for haircuts and shaves shall be as follows: \"Haircut for adults, male and female: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.$0.60 Friday, Saturday and holiday eves and the two days before Christmas and New Year's Day.0.65 Haircut for children, male and female, under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thrusday.0.40 Friday, Saturday and holiday eves and the two days before Christmas and New Year's Day.0.55 Brush-cut, semi brush-cut and Hollywood haircut: Monday, Wednesday and Thursday.0.90 Friday, Saturday and holiday eves and the two days before Christmas and New Year's Day.1.00 Ordinary shave.0.30 Beard cut with scissors.9.40\" (Document \"D\" annexed to the Order).A.MORISSET, 28944-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1316 Quebec, November 30, 1950 Present: The Lieutenant-Governor in Council Part \"E\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, I960, Vol.82, No.Ifl 3099 Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments to the decree relating aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse to the barber and hairdressing trades in the dans la région de Québec.district of Quebec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 3365 du *r septembre 1944, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 7 octobre 1950; Attendu que les objections formulées ont été appréciés conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 3365, soit modifié comme suit: 10 Les paragraphes \"a\" et \"b\" de l'article IV sont abrogés et remplacés par les suivants: \"a) Dans la zone I, le salaire minimum d'un employé régulier est de $30.00 par semaine, plus 50% des recettes de son travail au-delà de S 10.00 par semaine.\" \"b) Dans la zone II, le salaire minimum d'un employé régulier est de $25.00 par semaine, plus 50% des recettes de son travail au-delà de §35.00 par semaine.\" 2° Le paragraphe '*d\" de l'article IV est amendé en remplaçant les mots: \"excédant de plus de $9.00\" par les mots: \"excédant de plus de S 10.00\".3° Le paragraphe \"/\" de l'article IV est abrogé et remplacé par le suivant : \"/) Les employés surnuméraires ont doit à un salaire quotidien de $5.00 dans les zones I et III et de' $4.00 dans les zones II, IV, V, VI, VII, et VIII, à l'exception du samedi et des veilles de fêtes chômées alors qu'ils doivent recevoir S5.00.\" 4° Le sous-paragraphe intitulé \"zone II\" du paragraphe \"a\" de l'article V est remplacé par le suivant: \"Zone II: Le lundi: de 8.00 a.m.à midi.Les mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 7.00 p.m.IjCs vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.\" 5° Les prix minima .déterminés à l'article XII, pour les services ci-après mentionnés, dans les zones I et II, sont remplacés respectivement par les suivants: \"Zone I: Coupe de cheveux pour adultes des deux sexes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.$0.60 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.0.65 Coupe de cheveux pour enfants au-dessus de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.40 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées .0.50 Coupe de cheveux en brosse ou aux ciseaux.0.75 Coupe de la barbe.0.35 Massage.0.50 Flambage des cheveux (dans les salons de barbier).0.35 Lotion.'.0.35 Aiguisage de rasoir.0.50 Tonique.0.35\" Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the district of Quebec, rendered obligatory by the decree number 3365 of September 1, 1944, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree and its amendments; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of October 7, 1950; Whereas the objections set forth have been considered in pursuance of the Act; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 3365, be amend ed as follows: 1.Subsections \"a\" and \"6\" of section IV are deleted and the following substituted therefor: \"a) In zone I, the minimum wages of a regular employee is $30,00 per week plus 50% of the receipts of his work exceeding $40.00 per week.\" \"b) In zone II, the minimum wages of a regular employee is $25.00 per week plus 50% of the receipts of his work exceeding $35.00 per week.\" 2.Subsection \"d\" of section IV is amended by substituting the words \"exceeding by more than $.900 for the words \"exceeding by more than $10.00.\" 3.Subsection \"/\" of section IV is deleted and the following substituted therefor: \"/) Occasional employees are entitled to a daily remuneration of $5.00 in zones I and IH, and of $4.00 in zones H, IV, V, VI, VÏÏ and VIII, excepting Saturday and holiday eves when they shall receive $5.00.\" 4.The paragraph headed \"Zone II\" in subsection \"o\" of section V, is replaced by the following: \"Zone II: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 7.00 p.m.Friday Saturday, and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.\" 5.The minimum prices mentioned in section XII, for the services hereafter mentioned, in zones I and II are replaced by the following: \"Zone I: Haircut for adults, male and female: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.$0.60 Friday, Satu rday and holiday eves.0.65 Haircut for children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.40 Friday, Saturday and holiday eves.0.50 Haircut, brush or scissors.0.75 Shave.0.35 Massage.0.50 Singeing of the hair (in barber shops).0.35 Lotion.0.35 Razor setting.0.50 Tonic.0.35\" 3100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Les mots et chiffres: 'Massage-lotion.0.25\" mentionnée l'article XII pour la zone I, sont biffés.\"Zone II: Coupe «le cheveux pour adultes des deux sexes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.\"0.50 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.0.55 Coupe de cheveux pour enfant au-«lessous de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.35 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées .0.45 Coupe de la barbe.0.30 Coupe de cheveux en brosse ou aux ciseaux.0.75\" (Document \"E\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 28944-0 Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers AVIS Concernant l'abolition de la Cour des commissaires d'Asbestos Avis est donné que, par l'arrêté en conseil numéro 1239 du 16 novembre 1950, et conformément aux dispositions de l'article 154 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 15, il a plu au Lieutenant-gouverneur-en-conseil : o) de décréter l'abolition de la Cour des commissaires d'Asbestos; et b) d'ordonner la transmission des dossiers et archives de ladite Cour des commissaires d'Asbestos à la Cour de magistrat du district électoral de Richmond à Asbestos.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 21 novembre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28838-47-5-0 JEAN BRUCHÉSI.Régie Provinciale de L'Électricité AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné à tous intéressés que The Shawinigan Water and Power Company, et Quebec Power Company, ont par leur requête demandé à la Régie l'autorisation d'appliquer leurs tarifs respectifs pour service général ou commercial à la charge totale utilisée pour service domestique, lorsque l'abonné se sert du service électrique pour chauffage de maison.Toute personne ayant des représentations à faire au sujet de la dite demande devra s'adresser au soussigné, 132 rue St-Jacques ouest, à Montréal, P.Q.avant le 10 janvier, 1951.Régie Provinciale de L'Électricité, Par: J.-A.MORIN, 28864-48-2-0 Secrétaire.Hodge Bros.Ltd.Règlement N° 27 \"Qu'il soit décrété que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois à quatre.\" The words and numerals \"Massage-lotion .0.25\", mentioned in section XII for zone I, are deleted.\"Zone II: Haircut for adults, maie and female: Mon«lay, Tuesday, Wednesday an«l Thursday.0.50 Friday, Saturday an«l holiday eves.0.5.\") Haircut for children uwler 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday an«l Thursday .».0.35 Friday, Saturday ami holiday eves.0.45 Shave.0.30\" Scissors haircut or brushcut.0.7\">\" (Document \"E\" annexed to the Order) A.MORISSET, 28944-0 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices NOTICE Concerning the discontinuance of the Commissioners' Court of Asbestos Notice is hereby given that, by Order in Council No.1239 of the 16th of November, 1950.and according to the provisions of section 154 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 15), the Lieutenant-Governor in Council has been pleased: a) to enact the discontinuance of the Commissioners' Court of Asbestos; and .6) to order that the records and archives of the said Commissioners' Court of Asbestos be transmitted to the Magistrate's Court for the electoral district of Richmond at Asbestos.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-first day of November, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28838-47-5 Under Secretary of the Province.Provincial Electricity Board PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to all interested parties that The Shawinigan Water and Power Company, and the Quebec Power Company, have, by their petition, requested the Board, the authorization to apply their respective tariffs for general or commercial service to the total charge used for domestic service, when the subscriber uses electric power for heating a house.Any person having representations to make with regard to the sai«l petition shall apply to the undersigned, 132 St.James Street West, Montreal, P.Q., before the 10th day of January, 1951.Provincial Electricity Board, Per: J.A.MORIN, 28864-48-2 Secretary.Hodge Bros.Ltd.By-law No.27 \"Be it enacted that the number of the Directors of the Company be increased from three to four.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3101 Nous, les soussignés, certifions par les présentes que le règlement ci-dessus de \"Hodge Bros.Ltd.\" a été passé par le bureau de direction à une assemblée du 25 septembre 1950 et approuvé à l'unanimité par tous les actionnaires à une assemblée générale spéciale tenue le même jour.Montréal, le 25 septembre 1950.(Sceau) Le Président, RUSSELL A.HODGE.Le Secrétaire, 2S920 GORDON L.HODGE.The Tétreaultville Women's Club Règlement \"A\" Attendu qu'en vertu des dispositions que des lettres patentes constituant en corporation \"The Tétreaultville Women's Club\", le bureau de direction de cette corporation comprendra quatre personne, et .Attendu qu'il est dans l'intérêt de la corporation que le nombre de ses directeurs soit augmenté à seize : Qu'il soit et il est par les présentes décrété comme un règlement de la corporation, comme suit: Le nombre des directeurs de la corporation, fixé à quatre par les lettres patentes, est, par les présentes augmenté à seize.Certifiée copie conforme.La Secrétaire-archiviste, ETHEL WHITE, 28921 .(Mrs.J.A.White).Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 17 novembre 1950, le règlement N° 1 de la compagnie \"Waterloo School of Ballet Incorporated\", et, ce conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 21 novembre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, ¦ 2S922 JEAN BRUCHÉSI.Burnett Investment Inc.Avis est donné par les présentes que le Règlement spécial \"X\" a été décrété par les directeurs de \"Burnett Investments Inc\"., le 30 novembre 1950, en vertu des dispositions de l'article 90 de la Loi des compagnies de Québec, pourvoyant à la distribution de l'actif de la compagnie parmi ses actionnaires.Montréal, le 1er décembre 1950.Le Secrétaire, 28923 ALEX.ADAMSON.Dupresnoy'Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) Règlement \"0\" Attendu que \"Dupresnoy Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) trouve qu'il est opportun de changer le siège social de la compagnie, de Duparquet, dans le canton de Duparquet, dans le district d'Abitibi, en la province de Québec, à la ville de Noranda en la province de Québec.We, tlnr undersigned, hereby certify that the above By-law of \"Hodge Bros.Ltd.\" was passed by the Board of Directors at a meeting of September the 25th, 1950, and unanimously approved by all the Shareholders at a special general meeting held on the same day.Montreal, September the 25th, 1950.(Seal) RUSSELL A.HODGE, President GORDON L.HODGE, 28920-o Secretary.The Tétreaultville Women's Club By-law \"A\" Whereas the Letters Parent incorporating \"The Tétreaultville Women's Club\" provide that the Board of Directors of the corporation shall consist of four persons, and Whereas it is in the interest of the corporation that the number of its directors be increased to sixteen : Be it and it is enacted as a By-law of the corporation as follows: The number of directors of the corporation, fixed at four by the Letters Parent, is hereby increased to sixteen.Certified a true copy.ETHEL WHITE, (Mrs.J.A.White), 2892l-o Recording Secretary.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-law No.1 of the \"Waterloo School of Ballet Incorporated\" was approved by the Honourable the Provincial Secretary on November 17th, 1950, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act (R.S.Q.1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of November, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28922-o Under-Secretary of the Province.Burnett Investment Inc.Notice is hereby given that Special By-law \"X\" was enacted by the Directors of \"Burnett Investments Inc.\", on November 30th, 1950, under the provisions of Section 90 of the Quebec Companies' Act, providing for the distribution of the assets of the Company among its Shareholders.Montreal, December 1st, 1950.ALEX.ADAMSON, 28923-0 Secretary.Dupresnoy Mines Limited (No Personal Liability) By-law \"0\" Whereas \"Dupresnoy Mines Limited\" (No Personal Liability) deems it advisable to change the principal office of the Company from Duparquet, in the Township of Duparquet, in the District of Abitibi, in the Province of Quebec, to the Town of Noranda, in the Province of Quebec. 3102 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Qu'il soit et il est par les présentes décrété, comme un règlement de la compagnie, que le Règlement N° 1 des règlements généraux de la compagnie, soit rescindé et que le règlement suivant lui soit substitué comme Règlement N°l des Règlements généraux de \"Dupresnoy Mines Limited (Libre de responsabilité per-sonclle).Siège .social 1.Le siège social de la compagnie sera à la ville de Noranda, en la province de Québec.\" Décrété par les directeurs, ce 1 Génie jour de novembre 1950.(Sceau) Le président, W.B.MAXWELL.Le Secrétaire, 28932 A.G.FULTON.Avis est donné par les présentes que, sur recommandation de l'Assistant-procureur général, les règlements de la compagnie \"Ladies Free Loan Society\", comprenant les articles 1 à 20 inclusivement ,tels qu'adoptés à l'assemblée générale tenue le 16 novembre 1949, ont été approuvés par l'honorable Secrétaire de la Province, le 29 août 1950, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies tie Québec, (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 30e jour d'août 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28935 JEAN BRUCHÉSI.Now therefore be it and it is hereby enacted as a By-law of the Company that By-law No.1 of the general by-laws of the Company be rescinded and that the following be substituted as By-law No.1 of the general by-laws of \"Dupresnoy Mines Limited\" (No Personal Liability): \"Principal Office 1.The principal office of the Company shall be at the Town of Noranda, in the Province of Quebec.\" Enacted by the Directors this 16th day of November, 1950.(Seal) W.B.MAXWELL, President.A.G.FULTON, 28932-0 Secretary.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the By-Laws of the \"Ladies Free Loan Society\", comprising articles 1 to 20 inclusive, as adopted at the general meeting held on November 16th 1949, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on August 29th, 1950, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276).(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of August, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28935-o Under Secretary of the Province.Mansions limited Sommaire du Règlement N° 44 des Règlements de la Province Il a été décrété: Que les actifs de la Compagnie soient distribués proportionnellement parmi les actionnaires.Passé à la Cité de Montréal, le 4e jour de décembre 1950.Le Président, 28936-0 PRESTON G.PRINCE.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le deux décembre 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"L'Union des Travailleurs du- Bois de Mégantic\", et ce, conformément aux dispsoitions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chaptre 162, telles qu'ajoutées par le Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 5 décembre 1950.Le Sous-secrétaire de la province, 28940-o JEAN BRUCHÉSI.Mansions Limited Summary of By-Law No.44 of the Company's By-Laws It was enacted: That the Assets of the Company be distributed rateably among the Shareholders.Passed at the City of Montreal, on the 4lh day of December, 1950.PRESTON G.PRINCE, 28936-0 President.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, on December'2nd, 1950, enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"L'Union des Travailleurs du Bois de Mégantic\", and such pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.( Dated at the office of the Provincial Secretary, December 5, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28940 Under Secretary of the Province, AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le 1er décembre 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Syndicat Professionnel des Employés NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, on December 1st, 1950, enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Syndicat Professionnel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3103 de Dionne Automobiles Enr'g\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 102, telles qua'joutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 5 décembre 1950.Le Sous-secrétairc de la province, 28940-o JEAN BRUCHÉSI.Bennett (Quebec) Limited Résumé d'un règlement spécial de la compagnie concernant le paiement des obligations de la compagnie, la distribution de son actif et l'abandon de sa charte, adopté à une assemblée des directeurs tenue le 11 août 1950, ratifié par les actionnaires à la même date.a) La compagnie cessera d'opérer sauf pour la liquidation de ses affaires; b) La compagnie verra à payer toutes ses obligations; c) La compagnie transférera son actif à ses actionnaires au prorata des actions déternues; (l) Subséquemment la compagnie présentera unerequête pour l'abandon de sa charte; Je, soussigné, Maurice Gagné, avocat, secrétaire de \"Bennett (Quebec) Limited\", certifié que ce qui précède est un résumé fidèle d'un \"Règlement spécial concernant le paiement des obligations, la distribution de l'actif de la compagnie et l'abandon de sa charte\" adopté par les directeurs et ratifié par les actionnaires le 11 août 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 28945-0 MAURICE GAGNÉ.des Employés de Dionne Automobiles Enr'g.\" and such pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Dated at the office of the Provincial, Secretary, December 5, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28940 Under Secretary of the Province.(Bennett (Quebec) Limited Summary of a special by-law of the company respecting payment of the liabilities of the company, the distribution of its assets and of surrender of its charter adopted at the meeting of the Directors on August 11, 1950 and ratified by the shareholders on the same date.a) The company shall cease to carry on business except for-the winding up of its affairs; b) The company shall arrange for payment for its liabilities; c) The company shall transfer its assets to its shareholders on a prorata basis; d) Subsequently the company shall apply for surrender of its charter.I, the undersigned, Maurice Gagné, advocate, secretary of \"Bennett (Quebec) Limited, certify that the above is a faithful summary of a \"Special Jay-law respecting the payment of liabilities, the distribution of the assets of the company and the surrender of its Charter\" adopted by the Directors and ratified by the shareholders on August 11, 1950.(Seal) MAURICE GAGNÉ, 28945-0 Secretary.Bills, Assemblée législative Bills, Legislative Assembly Avis de l'Assemblée Législative Notice from the Legislative Assembly Concernant les bills privés qui seront présentés Relating to private, bills to be introduced durait cours de la présente session.ing the present session.Aux termes d'une motion adoptée par l'As- Under the terms of a motion adopted by the semblée législative le 16 novembre 1950, les Legislative Assembly on the 16th of November, délais fixés par le règlement concernant la dé- 1950, the delays fixed by the rules and standing position des bills privés chez le secrétaire des orders concerning the deposit of private bills comités ont été prolongés au 10 janvier 1951 with the Secretary of Committees have been et ceux de leur présentation au 14 février 1951; extended to the 10th day of January, 1951, and les délais fixés pour la présentation des pétitions those for their presentation to the 14th day of introductives des bills privés ont été prolongés February, 1951; the delays fixed for the presen- au 1er février 1951 et ceux de leur réception au t at ion of petitions for the introduction of private G février 1951, et les délais prévus pour la ré- bills have been extended to the 1st of February, ception des rapports des comités élus charges .de 1951, and those for their reception to he 6th l'examen des bills privés ont été prolongés au of February, 1951, and the delays prescribed for 28 février 1951.receiving reports from select committees charged with the examining of private bills have been extended to the 28th of February, 1951.Québec, le 29 novembre 1950.Quebec, November 29, 1950.Le Greffier, ANTOINE LEMIEUX, 28908-48-8-o ANTOINE LEMIEUX.28908-48-8 Clerk.Chartes \u2014 Abandon de .Charters\u2014 Surrender of AVIS NOTICE Burnett Investments Inc.\u2022 Burnett Investments Inc.la compagnie \"Burnett Investments Inc.\" \"Burnette Investments Inc.hereby gives donne avis par les présentes qu'elle s'adressera notice that it will make application to the At- 3104 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1960, Tome 82, N° 49 au Procureur général en vertu des dispositions de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec, pour obtenir l'acceptation de l'abandon de sa charte à compter d'une date à être fixée par le Procureur général.Montréal, le 1er décembre 1050.1xj Secrétaire, 28924 ALEX.ADAMSON.SANITO CO.Avis est donné conformément à la Loi des Compagnies de Québec et ses amendements que la compagnie, \"Sanito Co.\", demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, P.Q.28 novembre 1950.Le Secrétaire, 28925-0 MARCELLE BÉGIN.Mansions Limited Avis d'application pour permission.d'abandonner la charte.Avis est donné du fait que \"Mansions Limited\" une corporation constituée en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, et ayant son siège social dans la cité de Montréal, Province de Québec, demandera au Procureur-général de la Province de Québec la permission d'abandonner sa charte en conformité avec les termes de la Loi des Compagnies de Québec.Daté en cette cité de Montréal, le quatrième jour de décembre 1950.Le Président, 28937-0 PRESTON G.PRINCE.torney General under the provisions of Section 26 of the Quebec Companies\" Act, for the acceptance of the surrender of its Charter on and from a date to be fixed by the Attorney General.Montreal, December 1st, 1950.ALEX.ADAMSON, 28924-0 Secretary.SANITO CO.Notice is given that, pursuant to the Quebec Companies' Act, and amendments thereto, the company \"Sanito Co.\" will apply for leave to surrender its charter.Montreal, P.Q., November 28, 1950.MARCELLE BEGIN, 28925 Secretary.Mansions Limited Notice of application for leave to surrender charter.Notice is hereby given that \"Mansions Limited\" a Corporation constituted under the Quebec Companies' Act, and having its Head Office in the City of Montreal, Province of Quel ice, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this fourth day of December, 1950.PRESTON G.PRINCE.28937-0 President.Bennett (Quebec) Limited Bennett (Quebec) Limited Avis est ici donné que \"Bennett (Quebec) Notice is hereby given that \"Bennett (Quebec) Limited\", une compagnie formée sous l'autorité Limited\", a corporation constituted under the de la Loi des Compagnies de Québec et ayant le Quebec Companies Act and having its head office principal siège de ses affaires dans la Cité de in the City of Quebec, will apply to the Attorney Québec, s'adressera au Procureur Général de la General of the Province of Quebec for leave to Province de Québec pour obtenir la permission surrender its charter under the provisions of the de remettre sa charte suivant les dispositions de Quebec Companies Act.la Loi des Compagnies de Québec.Daté à Québec, ce quatrième jour de décembre.Dated at Quebec, this fourth day of Decemher 1950.(Sceau) (Seal).Le Secrétaire MAURICE GAGNE, 28046-o MAURICE GAGNE.28946-0 Secretary.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Allen Furs Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5-janvier 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze novembre 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au procureur Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Allen Furs Inc.\".incorporated by letters patent dated the fifth day of January, 1945.Notice is also given that from and after the fifteenth day of November, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28943-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I o^ the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3105 général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Canadian Brassières Inc.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du sixième jour de septembre 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du premier jour de décembre 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du procureur général, ce deux décembre, 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Fur Products Inc.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 janvier 1948.Avis est de plus donné qu'à compter 1er décembre 1950 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le 2 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Garage Masson, Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 mai 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du 1er décembre 1950 ladite compagnie a été dissoute Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1950.N L'Assistant-procureur général, 2S943-0 L.DÉSILETS.accept the surrender of the charter of the company \"Canadien Brassières Inc.\", incorporated by letters patent date the sixth day of September, 1944.Notice is also given that from and after the first day of December, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Fur Products Inc.\", incorporated by letters patent date the fourteenth day of January, 1948.Notice is also given that from and after the first day of December, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Garage Masson, Ltée\", incorporated by letters patent dated the 30th day of May, 1949.Notice 'is also given that from and after the first day of December 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943 Deputy Attorney General.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Jeni-Lee Incorporated\" constituée en corporation par lettres patentes en'date du dix-huitième jour de décembre 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du premier jour de décembre 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du procureur général, ce deux décembre«1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Jeni-Lee Incorporated\", incorporated by letters patent dated the eighteenth day of December, 1944.Notice is also given that from and after the first day of* December, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943-o Deputy Attorney General.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276 Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subarticle 26, et sujet à la responsabilité décrétée ject to the liability enacted by section 27 of the par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur said Act, the Attorney General has been pleased général d'accepter l'abandon de la charte de la to accept the surrender of the charter of the compagnie \"La Compagnie Forgues, Ltée\", company \"La Compagnie Forgues, Ltée\" inconstituée en corporation par lettres patentes corporated by letters patent dated the 23rd en date du 23 mars 1950.day of Mareh, 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du 1er Notice is also given that from and after the décembre 1950 ladite compagnie a été dissoute.\" first day of December, 1950, the said company has been dissolved. 3106 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943-0 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Quebec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Les Immeubles St-Charles Gamier, Limitée\", constituée en corporation «par lettres patentes en date du 26 novembre 1947.Avis est de plus donné qu'à compter du 1er décembre 1950 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le 2 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Les Immeubles St-Charles Gamier, Limitée\", incorporated by letters patent dated the 26th day of November, 1947.Notice is also given that from and after the first day of December, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943 Deputy Attorney General.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, ** Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Mason & Parker of Canada, Limited\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 27 avril 1931.Avis est de plus donné qu'à compter du 1er décembre 1950 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le 2 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts *refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Montreal Newsdealers Supply Company, Limited\" constituée en corporation par letters patentes en date du 5 octobre 1922.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze november 1950.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Quebec Manganese Mines Limited\" (libre de responsabilité personnelle) constituée en corporation par lettres patentes en date du trente juillet 1947.* < Avis est de plus donné qu'à compter du quinzième jour de novembre 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du procureur général, ce seize novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Mason & Parker of Canada, Limited\", incorporated by letters patent dated the twenty-seventh day of April, 1931.Notice is also given that from and after the first day of December, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company.\"Montreal Newsdealers Supply Company, Limited\", incorporated by letters patent dated the fifth day of October, 1922.Notice is also given that from and after the fifteenth day of November, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28943-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, an4 subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Quebec Manganese Mines Limited (No personal liability\", incorporated by letters patent dated the thirtieth day of July, 1947.Notice is also given that from and after the fifteenth day of November, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the sixteenth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 28943-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.Ifl 3107 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétés par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Selecta Girdle Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 août 1945.\u201e Avis est de plus donné qu'à compter du 1er décembre 1950 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 2S943-0 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.lt.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a.plu au procureur général, d'accepter l'abandon de la charte de là compagnie \"The Martin Investments, Limited\" constituée en corporation par lettres patentes en date du trente juillet 1943.Avis est de plus donné qu'à compter du premier jour de décembre 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du procureur général, ce deux décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 28943 L.DÉSILETS.General Exports Ltd.Selon les disposition de la Loi des Compagnies de Québec, \"General Exports Ltd.\" donne par les présentes avis qu'elle demandera au Procureur-Général la permission d'abandonner sa Charte à compter de la date qu'il déterminera.Montréal, ce 5 décembre 1950.Les Procureurs de la Compagnie, SCOIT, HUGESSEN, MaCKLAIER, 28947-0 Chisholm, Smith, & Davis.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Selecta Girdle Inc.\", incorporated by letters patent dated the 8th day of August, 1945.Notice is also given that from aiid after the first day of Deccml>er, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943 Deputy Attorney General.Notice^is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said, Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"The Martin Investments, Limited\" incorporated by letters patent dated the thirteenth day of July, 1943.Notice is also given that from and after the first day of December, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 28943-o Deputy Attorney General.General Exports Ltd.In accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act, \"General Exports Ltd.\" hereby gives notice that it will apply to the Attorney General for leave to surrender its Charter from and after such date as he may determine.Montreal, December 5th, 1950.Scott, Hugessen, Macklaier, Chisholm, Smith & Davis, 28947-o Solicitors for the Company.Compagnie dissoute Avis est donné par les présentes que \"Commercial Realty Company\" une compagnie dûment constituée, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 13 septembre 1912, avec siège social à Montréal, dans le district de Montréal, a été dissoute à compter du 29èmc jour de novembre 1950, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, (S.R.Q.1941, chapitre 278).x Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 30 novembre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28926 JEAN BRUCHÉSI.Company Dissolved Notice is hereby given that \"Commercial Realty Company\", a company duly incorporated under the provisions of the Quebec Companies Act, by letters patent dated September 13th, 1912, with its chief place of business at Montreal, in the District of Montreal, has been dissolved on and from the 29th day of November, 1950, pursuant to the provisions of the Winding-up Act (R.S.Q.1941, chapter 278).Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of November, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 28926-o Under-Secretary of the Province.Demandes à la Législature Avis public est par les présentes donné que Dame Aldéa Bélanger, veuve de Louis A.Gosselin, de la Cité de Montréal, Gérard Gosselin, artiste, actuellement résident dans la Cité de Applications to Legislature Public notice is hereby given that Dame Aldéa Bélanger, widow of Louis A.Gosselin, of the City of Montreal, Gérard Gosselin, artist, presently residing in the City of New York, 3108 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1960, Tome 82, N° 49' New York, États-Unis d'Amérique, Marcel Gosselin, technicien, de la Ville Mont-Royal, et Industrial Finance Corporation Limited, une compagnie ayant son bureau-chef dans la Cité de Montréal, s'adresseront à la Législature de la province de Québec à la session actuelle pour obtenir une loi modifiant certaines dispositions d'un acte de donation passé devant Ulric Ra-beau, notaire le 10 août 1931, sous le N° 83 de son répertoire, entre feu Louis A.Gosselin et la dite Dame Aldéa Bélanger, comme donateurs, et les dits Gérard Gosselin et Marcel Gosscli, comme donataires, auquel acte de donation la dite Industrial Finance Corporation Limited était intervenante.Montréal, 13 novembre 1950.Les Procureurs des requérants, létourneau, monk, tremblay, 28785-46-4-0 Forest, Godbout, & De%chenes.AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Shawinigan Falls, dans le Comté de St-Maurice, s'adresseront à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine stssion, pour obtenir l'adoption d'une loi a) autorisant cette corporation à retenir les services d'un gérant; b) autorisant le secrétaire-trésorier, lorsqu'il doit donner avis d'une résolution relative à une émission d'obligations ou à un emprunt, à le faire au moyen d'un avis suc-cint décrivant la nature et l'objet de la résolution et invitant les contribuables à en prendre connais-.sance à son bureau; c) autorisant le paiement aux \\ Commissaires d'écoles d'une compensation annuelle au montant de mille dollars pour le Président et de six cents dollars pour les Commissaires, pour tenir lieu de frais de déplacement, de représentation et autres dépenses.Shawinigan Falls, ce 10 novembre 1950.Les Procureurs des requérants, 28768-46-4-0 DÉSILETS ET DESHALES.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que messieurs Isidore Jean, Henri McLean, Sylvio Lavoie, Edgar St-Jean, Francis Beaudet, Edgar Maltais et Alfredo Tremblay s'adresseront à la Législature à sa présente session pour lui demander d'adopter une loi pour ériger en municipalité de village, soit le nom de village de Chute aux Outardes, un territoire comprenant une partie du Canton de Raguencau, une partie de la Rivière aux Outardes et les îles qui s'y trouvent ainsi que les chemins, rues, ruelles ou partie d'iceux le tout renfermé dans les limites suivantes, à savoir: Partant d'un point d'intersection de la ligne separative des lots 9 et 10 du rang I du cadastre officiel du canton de Rague-neau avec la rive droite de la Rivière aux Outardes; de là, toujours en' référence au même cadastre, passent par les lignes et démarcations suivantes en contmuité les unes des autres: la dite ligne separative des lots 9 et 10 du rang I et celle des lots 7 et 8 du rang II; la ligne separative des rangs U et III en allant vers le nord-est et son prolongement à trvers le bloc A et la Rivière aux Outardes; la rive gauche de la Rivière aux Outardes dans des directions sensiblement sud-est et sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 9 et 10 du rang I et enfin ce dit prolongement jusqu'au point de départ, pour fins municipales seulement et avis est par les présentes donné que messieurs Albert Bouchard, William Tremblay, United States of America, Marcel Gosselin, technician, of the Town of Mount Royal, and Industrial Finance Corporation Limited, a company having its head office in the City of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at the current session for the passing of an Act varying certains provisions of a deed of donation passed before Ulfic Ra-beau, notary, the 10th of August, 1931, under No.83 of his minutes, between the late Louis A.Gosselin and the said Dame Aldéa Bélanger, as donors, and the said Gérard Gosselin and Marcel Gosselin, as donees, to which deed of donation the said Industrial Finance Corporation Limited, was an intervening party.Montreal, November 13th, 1950.Letourneau, Monk, Tremblay, Forest, Godbout & Deschenes, 28785-46-4-o Attorneys for petitioners.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the School Commissioners for the Municipality of Shawinigan Falls, in the County of St-Maurice, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, for the passing of an Act a) authorizing said Corporation to retain the services of a Manager; 6) authorizing the Secretary-Treasurer, when he must publish a notice of a resolution relative to a bond issue or to a loan, to do so by means of a brief notice describing the nature and the object of the resolution and inviting the rate-payers to consult it at his office; c) authorizing the payment to the School Commissioners of an annual compensation amounting to one thousand dollars for the President and to six hundred dollars for the Commissioners, for travelling and intertamment disbursements and other expenses.Shawinigan Falls, November 10th, 1950.DÉSILETS AND DESHAIES, 28768-46-4-0 Attorneys for the Petitioners.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Messrs.Isidore Jean, Henri McLean, Sylvio Lavoie, Edgar St-Jcan, Francis Beaudet, Edgar Maltais and Alfredo Tremblay, will apply to the Legislature of Quebec at its present session for an Act to incorporate the village of Chute aux Outardes to be formed of a territory comprising part of the township of Raguencau, part of Rivière aux Outardes and the Island therein as well as the highways, roads, lanes, all other thereof comprised in the following limits, to wit: Starting from the point of extension of the separating line of lots 9 and 10 of range I of the official cadastre of the township of Ragueneau with the northern shore of Rivières aux Outardes, thence, also in reference to the same Cadaster through the following lines and demarcations: the said separation line of lots 9 and 10 of range I and that of lots 7 and 8 of range II; the separating line of lots n and DU towards the North-East and its extension through block A and Rivière aux Outardes; the left shore of Rivière aux Outardes and approximately South-East and South-West direction to the extension of the separation line of lots 9 and 10 of range I, and finally this said extension to the starting point for muni-pal purposes only, and notice is hereby given that Messrs.Albert Bouchard, William Tremblay, Emery Tremblay, Horace Chouinard, Basile Tremblay, Antoine Desbiens and Edmond Gauthier, will apply to the Legislature QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3109 Horace Chouinard, Basile Tremblay, Emery Tremblay, Antoine Desbiens et Edouard Gauthier s'adresseront à la Législature à sa présente session, pour lui demander d'adopter une loi aux fins de constituer en corporation la municipalité de Ragueneau formée du territoire suivant: Une partie du canton de Ragueneau, une partie de la Rivière aux Outardes et du fleuve St-Laurent et les îles qui s'y trouvent ainsi que les chemins, rivières, lacs, cours deau ou partie d'iceux, le tout renfermé dans les limites suivantes, à savoir: partant d'un point marquant l'axe dé la Rivière aux Rosiers, à l'embouchure de la dite rivière; de là, en référence au cadastre officiel pour le canton de Ragueneau, passant par les lignes et démarcations suivantes en continuité les unes des autre»;-l'axe de la Rivière aux Rosiers, jusqu'au prolongement de l'arrière-ligne du canton de Ragueneau; ledit prolongement et la dite arrière-ligne du canton de Ragueneau et son prolongement jusqu'à l'axe de la Rivière aux Outardes; ledit axe de la Rivière aux Outardes jusqu'au prolongement de la ligne nord du Bloc A; ce dernier prolongement jusqu'à la rive gauche de la Rivière aux Outardes; ladite rive gauche de la Rivière aux Outardes jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs II et III; le dit prolongement à travers la Rivière aux Outardes et le bloc A et la dite ligne separative des rangs II et III jusqu'à la ligne separative des lots 7 et S du rang H; cette dernière ligne et la ligne separative des lots 9 et 10 du rang I prolongée jusqu'à la rive gauche de la Rivière aux Outardes; la dite rive gauche de la Rivière aux Outardes jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 31 du rang de la Rivière aux Outardes, canton de Manicouagan; une ligne droite imaginaire dans la Rivière aux Outardes et le fleuve St-Laurent jusqu'à un point à une distance de deux milles de l'embouchure de la Rivière aux Rosiers, sur une autre ligne imaginaire originant à l'embouchure de la Rivière aux Rosiers et ayant la direction sud astronomique; enfin cette dernière ligne imaginaire sur une distance de deux milles jusqu'au point de départ, pour fins municipales seulement.Québec, le 27 novembre 1950.L'Avocat des pétitionnaires, 2S8S0-48-4-o VICTOR TRÊPANIER, C.R.Avis public est par les présentes donné que la Cité de Shawinigan Falls s'adressera à la législature provinciale à sa présente session, pour faire modifier sa charte, le Statut 8, Edouard VII, 1908, Chapitre 95 et les différents statuts qui la modifient, sur les matières suivantes: a) Changement de la date de la confection des listes électorales; b) L'indemnité des membres du Conseil ; c) Interdiction ou réglementation des salles de danse; d) Réglementation de la construction des bâtisses; et établissement d'un zonage pour fins; de protection contre l'incendie et d'urbanisme c) Réglementation de l'émission de licences pour postes de taxis et restriction de leur nombre; /) Protection du commerce local durant la célébration du Cinquantenaire de la cité.Le Procureur de la cité de Shawinigan Falls RENE HAMEL.28848-47-4-0 of Quebec at its present session for the adoption of a bill to erect the municipality of Ragueneau formée! of the following territory: A territory comprising part of the township of Ragueneau, part of Rivière aux Outardes and St-Lawrence River and the Islands therein, as well as roads, rivers, lakes, water powers, all part thereof, the all comprised in the following limits to wit: Starting from a point indicating the middle of Rivière aux Rosiers to the mouth of the said river; thence with reference to the official cadaster for the township of Ragueneau, through the following lines and demarcations: the middle of Rivière aux Rosiers to its extension to the last line of the township of Ragueneau, the said extension and the said last line of the township of Ragueneau, the said extension and the said last line of the township of Ragueneau and its extension to the middle of Rivière aux Outardes to its extension to the Northern line of block A; this said extension up to the left shore of Rivière aux Outardes; the said left' shore of Rivière aux Outardes through the extension of the separating line of lots H and III the said extension through Rivière aux Outardes and block A and the said separating line of ranges II and IH up to the separating line of lots 7 and 8 of range II ; this last line and the separating line of lots 9 and 10 of range I extended to the Eastern Shore of Rivière aux Outardes, the said Eastern shore of Rivière aux Outardes up to the South West line of lot 31 of Rivières aux Outardes range, in the township of Manicouagan; an imaginary straight line of Rivière aux Outardes and St-Lawrence River and up to a point at a distance of two miles of the mouth of Rivière aux Rosiers, of another imaginary line starting at the mouth of Rivière aux Rosiers and in a South astronomic direction; finally the said last imaginary line for a distance of two miles up to the starting point, for municipal purposes only.Quebec, November 27th, 1950.VICTOR TRÊPANIER, K.C., 28880-48-4-o Attorney for petitioners.Public notice is hereby given that the City of Shawinigan Falls will apply to the Provincial Legislature at its present session to obtain certain amendments to its Charter, the Act 8, Edward VII, 1908, Chapter 95 and to various acts amending the same on the following matters.a) Changing the dates of the confection of the electoral lists; 6) The indemnity of the members of the Council; c) Regulating or prohibiting dance halls; d) Regulating the construction of buildings; and establishing of zoning in connection with fire protection and town planning; e) Regulating the issue of licences for taxis stands and limiting the number of taxis; /) Protecting the local trade during the celebration of the Fiftieth Anniversary of the City.RENE HAMEL, Attorney for the city of Shawinigan 28848-47-4-o Falls. 3110 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que les Commissaires d'école pour la municipalité de la cité de Thetford-Mines, dans le comté de Méganic, s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi leur accordant le pouvoir d'imposer et de prélever une taxe de vente de un pour cent dans les limites de la cité de Thetford-Mines.Thetford-Mines, 15 novembre 1950.Le Procureur des pétitionnaires, 28800-46-4-o ANTONIO BEÀUDOIN, C.R.AVIS Avis est par les présentes donné par la Ville de Plage Laval (Ville de Laval Ouest) qu'elle s'adressera à la Législature provinciale lors de sa session actuelle pour obtenir des amendements à sa charte, entr'autres pour l'établissement d'un dépotoir, et pour contracter un emprunt suffisant pour la construction d'un incinérateur et fosse septique.Montréal, 29 novembre 1950.Les Procureurs de la dite Ville de Plage Laval (Ville de Laval Ouest), 28891-48-4-0 Fauteux, Blain & Fatjteux.AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la Cité de Longueuil s'adressera à la présente session de la Législature de la Province de Québec pour obtenir l'adoption d'une loi interdisant l'affiliation à d'autres associations des membres et officiers de son corps de police et de sa brigade de protection contre l'incendie; pour ratifier ses règlements existant de construction et de zonage et demander l'adoption d'un autre règlement de construction et de zonage sans autre formalité que l'approbation du Conseil municipal et la publication dudit règlement; pour faire amender l'article 2 de la loi 14 George VI chapitre 97 et pour toutes autres fins.Montréal, le 23 novembre 1950.Les Procureurs de la Cité de Longueuil, LAMARRE & LAMARRE.28862-48-4-o Avis de bill Privé Avis est par la présente donné que la Corporation de la Ville de Louiseville, dans le comté de Maskinongé, s'adressera à la Législature de la Province de Québec à sa présente session; pour les fins suivantes: Pour confirmer et ratifier un contrat entre la la Corporation de la Ville de Louiseville et The Associated Textiles of Canada Limited, reçu devant Me Jean-Paul Chevalier, notaire, le 19 octobre 1950, en rapport aux taxes municipales devant être payées pour une période de 5 ans par la compagnie Associated Textiles.Louiseville, le 23 novembre 1950.Le Procureur de la Ville de Louiseville, dans le Comté de Maskinongé, 28863-48-4-o RÉMI PAUL.AVIS Avis est par les présentes donné que Dame Anna Girard, épouse contractuellement séparée PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the School Commissioners for the municipality of the City of Thetford-Mines, in the county of Megantic, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the' passing of an Act, granting them the power to impose and levy a sales tax of one per cent, within the limits of the City of Thetford-Mines.Thetford-Mines, November, 15 1950.ANTONIO BEAUDOIN, K.C., 28800-46-4 Attorney for the petitioners.NOTICE Notice is hereby given by Town of Plugc Laval (Town of Laval West) that it will apply to the Provincial Legislature at its actual session to obtain amendements to its charter, to wit: for the establishment of a dump and to contract a sufficient loan for the construction of an incinerator and septical trench.Montreal, November 29th, 1950.Fauteux, Blain & Fauteux, Attorneys for said Town of Plage Laval 28891-48-4-o (Town of Laval West) PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the City of Longueuil will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an Act prohibiting the affiliation to other associations of the members and officers of i^s police force and its fire brigade; to ratify its exsiting building and zoning by-laws and apply for the adoption of another building and zoning by-law without any other formality than that of the approval of the Municipal Council and the publication of the said by-law; to have section 2 of the Act 14 George VI chapter 97 amended and for all other purposes.Montreal, November 23, 1950.LAMARRE & LAMARRE, Attorneys for the City of Longueuil.28862-48-4 Notice of Private Bill Notice is hereby given that the Corporation of the Town of Louiseville, in the county of Maskinongé, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session, for the following purposes: To confirm and ratify a contract between the Corporation of the Town of Louiseville, and The Associated Textiles of Canada Limited, passed before Me Jean-Paul Chevalier, notary, on October 19th, 1950, respecting the municipal taxes to l>e paid for a period of 5 years by the company Associated Textiles.Louiseville, November 23,1950.RÉMI PAUL, Attorney for the Town of Louiseville, 28863-48-4 in the county of Maskinongé.NOTICE Notice is hereby given that Mrs Anna Girard, wife legally separated as to property of J.Alfred QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3111 de biens de J.Alfred Brousseau, de la Ville de Mégantic, district de St.François, sollicitera auprès de la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi l'autorisant à vendre ou à hypothéquer en complète propriété, comme seule propriétaire le lot de terre numéro 2070, sur les plan et livre de renvoi officiels de la Ville de Mégantic, avec bâtisses, légué avec restrictions par feu Eugène Girard, peintre, de la Ville de Mégantic.Sherbrooke, le 30 novembre 1950.Le Procureur de la requérante, 28915-49-4-0 ARMAND NADEAU, C.R.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné par Dame Angelina Bacon, veuve de Réal Lamontagne, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à sa fille Lise, Roger Lamontagne, commis-marchand, René et Raoul Lamontagne, mar-\u2022 chants, tous de la Cité d'Outremont, district de Montréal, qu'ils demanderont à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, d'adopter une loi pour interpréter et compléter le testament de feu Réal Lamontagne, en son vivant marchand, de la Cité d'Outremont.Montréal, le 1er décembre 1950.L'Avocat des requérants, 2S910-49-4-o ÉMILLEN BRAIS.AVIS Avis est par les présentes donné que Dame Jeannine Legault, épouse de M.Raymond Girard, de la cité de Verdun, s'adressera à la Législature Provinciale à sa présente session pour demander de corriger le testament du Feu Henri Legault, daté le 4 septembre 1941.Montréal, le 30 novembre 1950.Le Procureur de la requérante, 28938-49-4-0 ROGER DESMARAIS, C.R.Avis public est par les présentes donné que la Cité de Grand'Mère et les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Mère dans le comté de Champlain s'adresseront conjointement à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins de ratifier à la fois le règlement numéro 461 de la dite Cité et une résolution desdits Commissaires d'écoles adoptée le 4 décembre 1950; ledit règlement et ladite résolution fixant tous deux, pour fins municipales et pour fins scolaires respectivement, le mode d'évaluation durant une période future de dix années des biens industriels imposables de The Shawinigan Water and Power Company et de Consolidated Paper Corporation Limited dans la municipalité de Grand'Mère; et ledit règlement numéro 461 pourvoyant additionnellement à la tenue de la comptabilité de la Cité, à l'adoption de ses budgets, au maintien de son administration par gérant et au mode d'aviser les compagnies lorsque des règlements sont soumis aux électeurs propriétaires.Grand'Mère, le 5 décembre 1950.Le Procureur de la Cité de Grand'Mère et des Commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Mère dans le comté de Champlain, 28948-49-4-0 MARCEI CRÊTE.Brousseau, of the Town of Mégantic, district of St.Francis, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act authorizing her to sell or mortgage in complete ownership, as sole owner, the lot number 2070, upon the official cadastral plan and in the book of reference of the Town of Megantic, with buildings, donated with restrictions by the late Eugene Girard, painter, of the Town of Mégantic.Sherbrooke, November 30th 1950.ARMAND NADEAU, K.C.28915-49-4-0 Attorney for the Petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given by Dame Angelina Bacon, widow of Réal Lamontagne, both personally and as tutrix to her daughter Lise, Roger Lamontagne, salesman, René and Raoul Lamontagne, merchants, all of the city of Outre-mont, district of Montreal, that they will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its session, for the passing of an Act to interpret and complete the Will of the late Real Lamontagne, in his lifetime a merchant, of the City of Outremont.Montreal, December'1, 1950.ÉMILIEN BRAIS, 28916-49-4 Attorney for petitioners.NOTICE Notice is hereby given by Mrs.Jeannine Legault, wife of Mr.Raymond Girard, of the city of Verdun, that she shall apply to the Quebec Legislature, durant its present Session to ask to amend the will of the late Henri Legault, dated September 4th 1941.Montreal, November 30th 1950.ROGER DESMARAIS, K.C.28938-49-4-o Attorney for Petitioner.Public notice is hereby given that the City of Grand'Mère and the School Commissioners for the Municipality of Grand'Mère in the County of Champlain will jointly apply to the Legisla ture of the Province of Quebec, at its present session for the passing of an Act to ratify a bylaw of the said City bearing number 461 as well as a resolution of the said School Commissioners adopted on December 4th 1950; both said by-law and said resolution fixing, for ten years, for municipal and for school purposes respectively the mode of valuation of the industrial taxable property of The Shawinigan Water and Power Company and of Consolidated Paper Corporation Limited within the municipality of Grand'Mère; and said by-law number 461 relating additionally to the accountancy of the City, to the adoption of its budgets, to the maintenance of its manager administration system and to the way of advising the companies when by-laws are submitted to the electors who are proprietors.Grand'Mère, December 5, 1950.MARCEL CRÊTE, Attorney for the City of Grand'Mère and the School Commissioners for the Municipality of Grand.-28948-49-4-0 Mere in the County of Champlain. 3112 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Avis est donné que L'Institut des Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne, constitué en corporation par la loi 6 Georges V, chapitre 103, s'adressera à la Législature de Québec, à sa session actuelle, pour obtenir des amendements à ladite loi aux fins suivantes: mieux définir ses buts et certains pouvoirs qu'il a actuellement; acquérir toutes propriétés mobilières et immobilières, pourvu que le revenu annuel des immeubles appartenant à la corporation et possédés par elle pour fins de revenus n'excède pas la somme de trois cent mille dollars: engager ses biens meubles et immeubles de toutes manières, pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations, contractés spécialement par émission d'obligations ou d'autres titres ou valeurs; défi nir que les pouvoirs de la corporation seront exercés par son conseil d'administration, composé ainsi qu'il sera statué; abroger (^article 7 de ladite loi et édicter des dispositions relatives à la dissolution de ladite corporation, à la représentation de ses membres par ladite corporation, aux officiers dont la signature liera celle-ci, à la modification du nom corporatif et du siège social de celle-ci, de même qu'à certains établissements et certaines constructions à ériger.Québec, 5 décembre 1950.Les Procureurs de L'Institut des Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne, 28949-49-4-0 GUÉRARD et PELLAND.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville LaSalle s'adressera à la Législature de la province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la Loi 2 Georges V, chapitre 73 et amendements, sur les matières suivantes: organiser ou subventionner un service de transport en commun dans ses rues et valider la subvention donnée à la Compagnie des tramways de Montréal durant l'année 1950; pouvoir d'acquérir ou construire tout égout public et imposer taxe pour en payer le coût; exiger compensation pour service d'égouts et pour autres fins.Montreal, ce 30 novembre 1950.Les Procureurs de Ville LaSalle, 28950-49-4-o Lacroix, Lafontaine & Viau.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville de Sainte-Rose s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la loi 8 George V, chapitre 98, sur les matières suivantes: imposer une taxe sur tous les propriétaires ou occupants d'immeubles de la municipalité pour la construction d'aqueduc public, citernes ou réservoirs; exiger des propriétaires d'immeubles une taxe pour le service de l'aqueduc lorsque la durée du bail est moindre qu'un an; permettre la modification des quartiers de la ville et faire représenter chacun des quartiers par deux éche-vins dont l'un sera élu par les propriétaires électeurs seulement et l'autre par tous les électeurs; exiger que chaque construction projetée soit érigé sur un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision; taxation des terres en culture; procédures pour exécution de travaux permanents; destitution du vérificateur, du directeur de la police et du secrétaire Notice is given that The Institute of the Sisters of the Childhood of Jesus and Mary, or Sisters of St.Chrétienne, a body incorporated under the Act 6 George V, chapter 103, will apply to the Legislature of Quebec, at its present session, in order to obtain amendments to said Act, as follows: define more clerly its aims and certain powers that he now possesses; acquire all moveable and immoveable property, provided that the annual revenue of the immoveables belonging to the corporation and owned by it for purposes of revenue does not exceed three hundred thousand dollars; encumber its immoveable of immoveable property in any way wer, to secure the payment of its loans of the carrying of its obligations, specially by issuing bonds or other title-deeds or securities; declare that the powers of said corporation shall be exercised by its council of administration, composed in the manner which shall be defined; repeal section seven of said Act and enact dispositions relating to the dissolution of said corporation, to the representation by said corporation of its membeis, to the officers whose signatures shall bind said corporation, to the altering of its corporate name of the place of its corporate seat, and to certain establishments and buildings to be erected.Quebec, December 5th, 1950.GUÉRARD and PELLAND, Attorneys for The Institute of the Sisters of the Childhood of Jesus and Mary, or Sisters of St.Chrétienne.28949-49-4-0 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of LaSalle will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act amending its charter, the Acte 2 George V, chapter 73 and amendments, for the following purposes: to organize or to subsidize a public service transportation on its streets and to validate the subsidy given to the Montreal Tramways Company for the year 1950; to obtain the power to acquire or to build any public sewers and to impose a tax to pay the costs of same: to exact compensation for the sewer service and for other purposes.Montreal, November 30th, 1950.Lacroix, Lafontaine & Viau, 28950-49-4-o Attorneys for the Town of LaSalle PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of Sainte-Rose will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session for the adoption of a law amending its charter the Act 8 George V, chapter 98, for the following purposes: to impose a tax on all the owners or occupants of immoveables of the municipality for the construction of water-works, public wells, cisterns or reservoirs; to exact from the property-owners a compensation for the water service when the term of the lease is under one year; to allow the modification of the wards of the town and to have two aldermen representing each ward, one to be elected by the property-owners only and the other by all the electors; to exact that each proposed building be erected on a distinct lot on the official plan of the cadastre or on a subdivision plan; taxation of farm lands; proceedings for the execution of permanent works; destitution of the auditor, of the director of the police department and of the secretary-treasurer QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol 82, No.49 3113 trésorier, conformément au chapitre 235* des Statuts Refondus de Québec 1941; procédures concernant contravention aux règlements municipaux relatifs à la circulation et à la sécurité publique; création d'un fonds de roulement; encouragement des arts, sciences, établissement de ce îtres de loisirs et organisation des jeux et des sports et pour autres fins.Montréal, ce 5 décembre 1950.Les Procureurs de la Ville de Sainte-Rose, 2S951-49-4-o Lacroix, Lafontainb & Viau.according to Chapter 235 of the Revised Statutes of Quebec, 1941 ; proceedings concerning offences to the traffic and public securities by-laws of the town; encouragement to the arts, sciences establishment of recreation centers and organisation of games and sports and for all other purposes.Montreal, December 5th, 1950.Lacroix, Lafontaine & Viau, Attorneys for the Town of Sainte-28951-49-4-o Rose.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec Ordonnance N° 66-50 Extrait des procès verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi, 6 décembre 1950 tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Québec, à 10 heures du matin.Présents: MM.Orner E.Milot, président, Joseph Hébert, Adrien.Angers, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, C.-A.Gamache, c.r., A viseur légal et Roland Camirand Inspecteur général des Produits laitiers.Après avoir considéré les conditions de l'Industrie laitière dans la région de Nicolet.La Commission décrète ce qui suit: 1° La présente \"ordonnance s'applique à toute personne qui, directement ou indirectement, vend ou livre du lait dans les limites de la région de Nicolet.2° Le région de Nicolet comprend la municipalité de la ville de Nicolet.3° Tout marchand de lait doit payer directement à ses fournisseurs-producteurs, pour chaque cent livres de lait qu'il reçoit de ceux-ci, 84.10 net, F.A.B.la place d'affaires du dit marchand, et, à même cette somme, payer à la commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec un demi-cent par cent livres de lait ainsi reçu.4° Sauf les dispositions de l'article 5 ci-dessous, nul ne peut, dans les limites de la région de Nicolet, offrir, vendre ou livrer du lait à des prix inférieurs à 5 cents le demiard, 9 cents la chopine et 17 cents la pinte.5 Nul ne peut dans les limites de la région de Nicolet offrir, vendre ou livrer du lait à une épicerie, à un hôtel, à un restaurant, à un marchand ou à tout autre établissement de commerce à des prix inférieurs 8% cents la chopine et 1G cents la pinte.6° Nul ne peut vendre du lait en bidon à un prix inférieur à 64 cents le gallon.La présente ordonnance annule l'ordonnance N 66-48B, publié dans la Gazette officielle de Québec, du 22 mai 1948 et entrera en vigueur le 16 décembre 1950.Le secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans Ja Gazette officielle de Québec.Signé: Omer E.Milot, Président, Joseph Hébert, Commissaire, Adrien Angers, Commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, Secrétaire.28957-0 - Department of Agriculture Dairy Industry LIairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.66-50 Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the .province of Quebec.Meeting of Wednesday, December 6th, 1950, held in the office of the (Dairy Industry Con mission in Quebec, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Omer E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, C.-A.Gamache, K.C, Legal Adviser and Roland Camirand, Inspector General of Dairy Products.Considering the conditions of the dairy industry within the region of Nicolet.It is enacted as follows: 1.The present order is applied to any person who, directly or indirectly, sells or delivers milk within the limits of the region of Nicolet.2.The region of Nicolet includes the town of Nicolet.3.Any milk dealer must pay to his producers-suppliers for each hundred pounds of milk which he receives from them, $4.10 F.O.B.business place of said dealer, and out of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec one half cent for each hundred pounds of milk received.4.Save the provisions of article 5 hereunder, no person shall, within the limits of said region of Nicolet offer, sell or deliver milk at prices inferior to 5 cents per half-pint, 9 cents per pint and 17 cents per quart.\u20225.No person shall, within the limits of said region of Nicolet offer, sell or deliver milk to a grocery, a hotel, a restaurant, a dealer or to any other business establishment at prices inferior to 8]/2 cents per pint and 16 cents per quart.6° No person shall sell milk in bulk at a price inferior to 64 cents a gallon.The present Order cancels Order No.66-48B published in the Quebec Official Gazette of May 22nd, 1948, and shall come into force on October 16th, 1950.Thf Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in tjie Quebec Official Gazette.Signed: Omer E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner, Certified: Alphonse Savoie, Secretary.27957-0 - 3114 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec Ordonnance N° 57-50'A Extrait des procès verbaux des séances de la Commission de l'Industrie \\ Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi, 6 décembre 1950, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Québec, à 10.00 heures .am.Présents: MM.Omer-E.Milot,.président, Joseph Hébert, Adrien Angers, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, C.-A.Gamachc, c.r., Aviseur légal et Roland Camirand, Inspecteur général des Produits laitier .Après avoir considéré les conditions de l'industrie laitière dans la région de Victoriaville.La Commission décrète ce qui suit: 1° La présente ordonnance s'applique à toute personne qui, directement ou indirectement, vend ou livre du lait dans les limites de la région de Victoriaville.2° La région de Victoriaville comprend la ville de Victoriaville, la paroisse Ste-Victoire, la ville d'Arthabaska, le village de Warwick et le village de Plessisville.3° Tout marchand de lait doit payer directement à ses fournisseurs-producteurs, pour chaque cent livres de lait qu'il reçoit de ceux-ci, $4.15 net, F.A.B.la place d'affaires du dit marchand, et, à même cette somme, payer à la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec un demi-cent par cent livres de lait ainsi reçu.4° Sauf les dispositions de l'article 5 ci-dessous, nul ne peut, dans les limites de la région de Victoriaville, offrir, vendre ou livrer du lait à des prix inférieurs à 5 cents le demiard, 9 cents la chopine et 17 cents la pinte.5 Nul ne peut, dans les limites de la région de Victoriaville offrir, vendre ou livrer du lait à une épicerie, à un hôtel, à un restaurant, à un marchand ou à tout autre établissement de commerce à des prix inférieurs à 43^ cents le demiard, 8% cents la chopine et 16 cents la pinte.6° Nul ne peut vendre du lait en bidon à un prix inférieur à 60 cents le gallon.La présente ordonnance annule l'ordonnance N° 57-50, publiée dans la Gazette officielle de Québec du II novembre 1950, et l'ordonnance N° 68-48A, publiée dans la Gazette officielle de Québec du 17 janvier 1948, et entrera en vigueur le 16 décembre 1950.Le secrétaire de ladite Commission est chargé \u2022 de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer E.Milot, Président, Joseph Hébert, Commissaire, Adrien Angers, Commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, Secrétaire.28957-0 Département de l'Instruction publique N° 1309-44 Québec, le 28 novembre 1950.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Sacré-Cœur-de-Jésus, paroisse, dans le comté de Stantead, le lot 1020 et la partie des lots 1019 et 1138-A du cadastre officiel du canton de Stanstead, appartenant à Monsieur Ambroise Tétreault, et de les annexer à la muni- Dairv Undustry Commission of the Province of Quebec Order No.57-50A Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Wednesday, December 6th, 1950 held in the office of the Dairy Industry Commission, m Quebec, at\" 10.00 o'clock a.m.Present: Messrs.Omer E.Milot, President Joseph Hébert, Adrien Angers, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, C.-A.Gamache, K.C.Legal Adviser and Roland Camirand, Inspector General of Dairy Products.Considering the conditions of the dairy industry'within the region of Victoriaville.It is enacted as follows: 1.The present order is applied to any person ' who, directly or indirectly, sells or delivers milk within the limits of the region of Victoriaville.2.The region of Victoriaville includes the town of Victoriaville, the parish of Ste-Victoire the town of Arthabaska, the village of Warwick and the village of Plessisville.3.Any milk dealer must pay to his producers-suppliers for each hundred pounds of milk which he receives from them, $4.15 F.A.B.business place of said dealer, and cut of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec one half cent for each hundred pounds of milk received.4.Save the provisions of article 5 hereunder, no person shall, within the limits of said region of Victoriaville offer, sell or deliver milk at prices inferior to 5 cents per half-pint, 9 cents per pint and 17 cents per quart.5.No person shall, within the limits of said region of Victoriaville offer, sell or deliver milk to a grocery, a hotel, a restaurant, a dealer or to any other business establishment at prices inferior to 4J^ cents par half-pint, 8% cents per pint and 16 cents per quart.6.No person shall sell milk in bulk at a price inferior to 60 cents a gallon.The present Order cancels Order No.57-50, published in the Quebec Official Gazette of November 11th, 1950, and Order No.68-48A, published in the Quebec Official Gazette of January 17th, 1948, and shall come into force on December 16th, 1950.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in the Quebec Official Gazette.Signed: Omer E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner, Certified: Alphonse Savoie, Secretary.28957-o Department of Education No.1309-44 Quebec, November 28, 1950.Application is made to detach from the School Municipality of Sacré-Cœur-de-Jésus, parish, in the county of Stanstead, lot 1020 and that part of lots 1019 and 1138-A of the official cadastre for the county of Stanstead, belonging to Mr.Ambroise Tétreault, and to annex them QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3115 cipalité scolaire de Saint-Wilfrid-de-Barnston; môme comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 28882-48-2-0 par: B.-O.FILTEAU.N° 828-50.Québec, le 30 novembre 1950.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Luc, dans le comté de Saint-Jean, le lot 34 du cadastre officiel de la paroisse de St-Luc et de l'annexer à la municipalité scolaire de la Paroisse de Chambly, dans le comté de Chambly.Le Surintendant de l'Instruction publique, 28917-49-2-0 B.-O.FILTEAU.N° 770-50.Québec, le 30 novembre 1950.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1950, de changer le nom de la municipalité scolaire de Laflèche, dans le comté de Champlain, en celui de \"Saint-Stanislas, paroisse\" même comté.Ijc Surintendant de l'Instruction publique, 28927-0 Par B.-O.FILTEAU, N° 1559-40.Québec, le 1er décembre 1950.Demande est faite d'annexer le territoire de la municipalité scolaire du canton de Gpmby, pour les contribuables protestants seulement à la municipalité scolaire protestante de la Cité de Granby, dans le comté de Shefford.Le Surintendant de l'Instruction publique, 28952-49-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.to the School Municipality of Saint-Wilfrid-de-Barnston, same county.per: B.O.FILTEAU, 28882-48-2 The Superintendent of Education.No.828-50.Quebec, November 30, 1950.Application is made to detach from the school municipality of Saint-Luc, in the county of Saint-Jean, lot 34 of the official cadastre for the parish of St-Luc, and to annex it to the school municipality of the Parish of Chambly, in the county of Chamhlv.B.O.FILTEAU, 28917-49-2 The Superintendent of Education.No.770-50 Québec, November 30, 1950.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by order in council dated the 12th of July, 1950, to change the name of the school municipality of Laflèche, in the county of Champlain, into that of \"Saint-Stanislas, parish\", same county.Per B.O.FILTEAU, 28927 Superintendent of Education.9 - No.1559-40 Quebec, December 1, 1950.Application is made to annex the territory of the school municipality of the Township of Granby, for Protestant taxpayers only, to the Protestant school municipality of the City of Granby, in tlic county of Shefford.O.J.DÉSAULNIERS, 28952-49-2 Superintendent of Education.Département du Travail %AVIS I 'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne?avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que la \"Cuirs Saguenay Ltée lui a présenté une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante à la convention collective de travail relative aux tanneries et cor-roierics dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 523 du 5 février 1940.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 9 décembre, 1950.28955-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton gaufré lui a présenté une requête à l'effet de modifier comme suit, le décret numéro 561 du 11 mars 1942 et amendements, relatif à la fabrication de boîtes de carton, gaufré dans la province de Québec.st Department of Labour NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that Saguenay Leathers Limited has submitted to him a request to be accepted as co-contracting party to the collective labour agreement relating to the tanners and curiiers in the province of Quebec, rendered obligatory by the decree number 523 of February 5, 1940.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the HonourableMinister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 9, 1950.28955-0 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941 .chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of the Corrugated Paper Box Industry of Quebec has submitted to him aVequest to amend the decree number 561 of March 11, 1942, and amendments, relating to the manufacturing of corrugated paper boxes in the province of Quebec, in the following manner: 3116 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 Le premier alinéa de l'article IV sera remplacé par le suivant : \"IV Heures de travail et tavx de salaire pour travail supplémentaire: La durée du travail pour tous les salariés y compris les mécaniciens de machines fixes et les chauffeurs de bouilloires, les gardiens, les employés préposés à la réparation et à l'expédition est de cinquante (50) heures par semaine.Tout travail exécuté les jours de congé et les dimanches ou en plus de cinquante (50) heures par semaine par ces mêmes salariés devra être rémunéré à raison de salaire et demi, mais tout travail exécuté et payé au taux de salaire et demi lesdits dimanches et jours de congé ne sera pas inclus- dans les heures de travail hebdomadaires au moment de calculer le temps supplémentaire de la semaine.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBIAY.Ministère du Travail, Québec, le 9 décembre 1950.28955-0 - * AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité partitaice des métiers de la construction pour les comtés de St-Hyacin-the, Bagot et Rouville, lui a présenté une requête à l'effet de modifier comme suit, le décret numéro 2678 du 12 juillet 1940 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans les comtés de St-Hyacinthe, Bagot et Rouville: ¦ * Les dispositions suivantes seront ajoutées après le premier alinéa du paragraphe g\" de l'article IV: \"Pour ce qui concerne les rajustements trimestriels, le Comité paritaire prendra comme base l'indice fédéral du coût de la vie des mois de février pour le rajustement de mai, de mai pour août, d'août pour novembre, de novembre pour février.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis d ns la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 9 décembre 1950.28955-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1942, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 2375 du 11 septembre 1937, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements, de* la façon suivante: 1° L'article VII sera remplacé par le suivant: \"VIL\u2014a.\u2014Taux minima pour le travail à la semaine: L'échelle suivante de salaires minima The first paragraph of section IV will be replaced by the following: \"IV Hours of Labour and wage rates for over, time work:T\\\\c duration of work for all employees including stationary engincmen and fireman (stokers), maintenance, shipping men, watch-man, is fifty hours (50) per week, and any hours of work exceeding fifty (50) hours in any one week or performed on holidays and Sundays by such employees is to be paid at the rate of time and one half, but hours worked.and paid at the rate but hours worked and paid at the rate of time and one half on such holidays and Sundays will not be included in the total weekly hours worked when computing the weekly overtime.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of labour.Department of Labour, Quebec, December 9, 1950.28955-0 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to t he provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Building Trades Parity Committee for St.Hyacinthe, Bagot and Rouville Counties has submitted to him a request to amend the decree number 2678 of July 12, 1940, and amendments, relating to the construction industry in the counties of St.Hyacinthe, Bagot and Rouville, in the following manner: The following provions will be added after the first paragraph of subsection \"g\" of section IV:.\"As regards quarterly wage readjustments, the Parity Committee shall compute same upon the Federal Cost of Living Index of the month of February for the May readjustment, of May for the August readjustment, of August for the November readjustment, of November for the February readjustment.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 9, 1950.28955-0 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941), chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the ladies cloak and suit industry in the province of Quebec, rendered obligatory by the decree number 2375 of September 11,1937, have submitted to him a request to amend the said decree, and its amendments, as follows: 1.Section VII will be replaced by the following: \"VII.a) Minimum for week work: The following minimum scale of wages shall apply to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3117 i s'applique aux salariés ci-après énumérés, et ces salariés doivent travailler sur une base horaire ou hebdomadaire seulement; ils ne doivent pas travailler sur une base de travail à la pièce: l'heure Coupeur très compétent.$1.28 2-5 Coupeur moins compétent.97 3-5 Coupeur de fournitures.98 4-5 Tailleur de fournitures;.1.06 3-5 Aide-tailleur de fourrure.79 3-5 Faufileur à la machine.79 3-5 Opérateur de machine spéciale.79 3-5 Poseur de boutons.56 2-5 Ouvrier général.56 2-5 Examineur.56 2-5 b) Taux minima pour travail à la pièce: Les salariés des métiers énumérés ci-dessous peuvent travailler sur une base de travail à la pièce ou à la semaine mais, dans un cas comme dans l'autre, l'échelle de salaire suivante s'applique: l'heure Opérateur compétent.$1.28 2-5 Opératrice compétente.1.05 1-5 Opérateur ou opératrice qui travaille ensemble \"section operators\".1.28 2-5 Presseur de dessus.1.28 2-5 Presseur à la machine.1.28 2-5 Sous-presseur.1.22 Presseur de pièces.0.97 3-5 Opérateur moins compétent 0.97 3-5 Opératrice moins compétente.0.91 1-5 Faiseur de jupes.0.79 3-5 Faiseur de doublures.0.79 3-5 Finisseur.\\ .0.79 3-5 Faufileur à la main.0.79 3-5 Les taux à la pièce doivent être fixés de telle façon que les salariés des métiers ci-haut mentionnés reçoivent les taux honraires minima ci-dessus.Les taux à la pièce sont les mêmes pour les salariés des deux sexes.2° L'article IX sera remplacé par le suivant: \"IX.Le nombre des apprentis ne doit pas dépasser cinq pour cent (5%) de celui des ouvriers employés dans tout établissement.a) Apprentis-opérateurs, presseurs et tableurs de fourrure: Un appareil opérateur, presseur et tailleur de fourrure est un commençant et doit être rémunéré conformément à l'échelle suivantes Par semaine Premier semestre.$15.40 Après le premier semestre.19.28 Après le deuxième semestre.23.12 Après le troisième semesjtre.26.96 Après le quatrième semestre.30.80 Après le cinquième semestre.34.64 Après le sixième semestre.38.56 b) Apprentis-faiseurs de jupes, faiseurs de doublures, finisseurs, faufileurs à la machine, faufilcurs à la main et opérateurs de machine spéciale: Les apprentis-faiseurs de jupes, faiseurs de doublures, finisseurs, faufileurs à la machine, faufileurs à la main et opérateurs de machine spéciale doivent être rémunérés conformément à l'échelle suivante: Par semaine Premier semestre.$15.40 Après le premier semestre.19.28 Après le deuxième semestre.23.12 Après le troisième semestre.26.96 Après le quatrième semestre.31.84 c) Apprentis-coupeurs et coupeurs de fournitures: Un apprenti coupeur et coupeur «de fournitures est un commençant et il doit travailler jusqu'à sa qualification comme coupeur très compétent selon l'échelle suivante: employees hereinafter enumerated, and chus employees shall work on an hourly or week work basis only, and such employees shall not work on a piece work basis: per hour Full skilled cutter.$1.28 2-5 Semi-skilled cutter.0.97 3-5 Trimmer.0.98 4-5 Fur tailor.1.06 3-5 Assistant fur tailor.0.79 3-5 Machine baster.0.79 3-5 Special machine operator.0.79 3-5 Button sewer.0.56 2-5 General hand.\u2022.0.56 2-5 Examiner.0.56 2-5 b) Minimums for piece work: Workers in the crafts enumerated below may work on a piece or week work basis but, in either event, the following scale of wages shall apply: per hour Skilled operator (male).$1.28 2-5 Skilled operator (female).1.05 1-5 Section operator (male and female).1.28 2-5 Top presser.1.28 2-5 Machine presser.1.28 2-5 Under presser.1.22 Piece presser .!.0.97 3-5 Semi-skilled operator (male).0.97 3-5 Semi-skilled operator (female).0.91 1-5 Skirt maker.0.79 3-5 Lining maker.0.79 3-5 Finisher.0.79 3-5 Hand baster.0.79 3-5 Piece work rates must be fixed to yield to the employees in the above crafts the above minimum hourly rates.Piece work rates shall be the same for male and female employees.\" 2.Section IX will be replaced by the following: \"IX.Apprentices are limited to five per cent (5%) in number of the workers employed in the respective establishments.a) Apprentice Operators, Pressers and Fur Tailors: An apprentice operator, presser or fur tailor, is a beginner, and shall work under the following schedule: per week First six months.$15.40 At the end of six months.19.28 At the end of twelve months.23.12 At the end of eighteen months.26.96 At the end of twenty-four months.30.80 At the end of thirty months .^- 34.64 At the end of thirty-six months T.38.56 6) Apprentice skirt makers.Lining makers, Finishers, Machine Basters, Hand Basters and Special Machine Operators: Apprentice skirt makers, lining makers, finishers, machine basters, band basters and special machine operators shall work under the following schedule: > per week First six months.$15.40 At the end of six months.* 19.28 At the end of twelve months.23.12 At the end of eighteen months.16.96 At the end of twenty-four months.31.84 c) Apprentice Cutter sand Trimmers: An apprentice cutter and trimmer is a beginner and shall work until graduation into the craft of a full-skilled cutter-under the following schedule: 3118 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82,- N° 49 Par semaine pCr week Premier semestre.$15.40 First six months.$15.40 Après le premier semestre.19.28 At the end of six months.19.28 Après le deuxième semestre.23.12 At the end of twelve months.23.12 Après le troisième semestre.26.90 At the end,of eighteen months.26.96 Après le quatrième semestre.30.90 At the end of twenty-four months.30.90 Après le cinquième semestre.34.64 At the end of thirty months.34.04 Après le sixième semestre.38.56 At the end of thirty-six months.38.56 Après le septième semestre.44.96 At the end of forty-two months.44.96 Après le huitième semestre.51.36 At the end of forty-eight months.51.36 Le Bureau des examinateurs garde sous ob- The \"Board of Examiners\" shall examine each servation chaque coupeur moins competent et semi-skilled cutter and trimmer employed in the coupeur de fournitures pour une période mini- industry for a period of at least four years and mum de quatre années et décide s'il doit être shall determine his ability to become a full- classifîé comme coupeur très compétent.skilled cutter.Lorsque le Bureau des examinateurs juge If the \"Board of Examiners\" finds the appli- qu'un candidat est qualifié comme coupeur très cant qualified under the definition of full-skil- compétent, conformément aux définitions de led cutter as contained in the definitions of crafts métiers du présent décret, tel candidat est pro- herein, such applicant shall be promoted to the mu au métier de coupeur très compétent et ré- craft of full-skilled cutter and be paid the niiu- munéré à raison de $51.36 par semaine ou de inum rate of 51.36 per week, or $1.28 2-5 per $1.28 2'5 l'heure, tel que prévu dans le décret.hour as provided for in the decree.Le Bureau des examinateurs ^xuit aussi dé- The \"Board of Examiners\" may also deter- termincr que le candidat, quoique n'étant pas mine that the applicant although not fully qual- assez qualifié pour devenir un coupeur très com- ified to become a* full skilled cutter, is stilli- pétent, est suffisamment qualifié pour obtenir ciently qualified to obtain an increase over his une augmentation de son taux actuel de salaire, present rates of pay if receiving less than S51.36 s'il reçoit moins que $51.36 par semaine, et per week, and shall determine such rates ac- ledit bureau déterminera tel taux en conséquence, cordingly.En tout temps après cette période le candidat At any future time the applicant may apply peut demander au Bureau des examinateurs to the \"Board of Examiners\" for graduation into d'être promu à la classe de coupeur trèseompé- the class of full-skilled cutter, and the \"Board tent, et le Bureau des examinateurs doit pi en- of Examiners\" shall forthwith deal with such dre telle requête en considération conformément request on the aforesaid basis, aux dispositions ci-haut.d) Apprentis-poseurs de boutons, ouvriers gê- d) Apprentice Button-sewers, General Hands nêraux et examinateurs: and Examiners: Les apprentis-poseurs de boutons, ouvriers Apprentice button-sewers, general hands and généraux et examinateurs terminent leur ap- examiners shall complete their apprenticeship prentissage à l'expiration de dix-huit (18) mois respectively at the end of eighteen (18) months et doivent être rémunérés d'après l'échelle sui- and shall work under the following schedule, vante, calculée-et fixée conformément aux dis- also computed and fixed in conformity with the positions du présent décret, à savoir: provisions of the present decree, namely: Par semaine per week Premier semestre.$15.40 First»*ix months.$15.40 Après le premier semestre.18.00 At the end of six months.18.00 Après le deuxième semestre.20.56 At the end of twelve months.2().\">(i Après le troisième semestre.' 22.60 'At the end of eighteen months.22.00 L'appientissage des métiers d'aide-opérateur All apprenticeship in the crafts of assistant faiseur de doublures, faiseur de jupes, faufileur operator, lining maker, skirt maler, machine à la machine et opérateur de machine spéciale, baster and special machine operator must be doit être terminé à la fin de la deuxième année completed at the end of the second year and, et, dans le cas de l'opérateur, à la fin de la troi- in the case of the operator, at the end of the sième année, sans tenir compte si un apprenti third year and irrespective as to whether or not a été employé dans un ou plusieurs de ces mé- such apprentice was employed in one or more of tiers consécutivement ou concurremment.Après the aforementioned crafts consecutively or con- ces périodes l'apprenti a droit au taux mini- currently, after which time and apprentice shall mum prévu dans le présent décret pour le mé- be entitled to the full minimum herein provided tier dans lequel il travaille.for the respective craft in which such apprentice is actually performing work.L'apprentissage des métiers, d'aidc-tailleur, All apprenticeship in the carfts of assistant finisseur, faufileur à la main, doit être terminé tailor, finisher, hand baster, shall be completed à la fin de la deuxième année et, dans le cas du at the end of the second year and, in the case tailleur de fourrure, à la fin de la troisième an- of a fur tailor, at the end of the third year, née, sans tenir compte si un apprenti a été em- irrespective as to whether or not such apprentice ployé dans un ou plusieurs de ces métiers con- was employed in one or more of the aforc- sédutivement ou concurremment.Après ces pé- mentioned crafts consecutively or concurrently, riodes, l'apprenti a droit au taux minimum after which time an apprentice shall be entitled prévu dans le présent décret pour le métier dans to the full minimum herein provided for the lequel il travaille.respective craft in which such apprentice is actually performing work.L'apprentissage des métiers de presseur de All apprenticeship in the crafts of top-press- dessus, sous-presseur et presseur à la machine ers, under-pressers and machine pressers shall doit être terminé à la fin de la troisième année, be completed at the end of the third year, irrcs- sans tenir compte si un apprenti a été employé pective as to whether or not such apprentice dans un ou plusieurs de ces métiers consécutive- was employed in one or more of the aforc- ment ou concurremment.Après cette période, mentioned crafts consecutively or concurrently, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3119 l'apprenti a droit au taux minimum prévu dans le présent décret pour le métier dans lequel il travaille.L'apprentissage des métiers de coupeur très compétent, coupeur moins compétent et coupeur de fournitures doit être terminé à la fin de la quatrième année, sans tenir compte si un apprenti a été employé dans un ou plusieurs de ces métiers consécutivement ou concurremment.Après cette période, l'apprenti a droit au taux minimum prévu dans le présent décret pour le métier dans lequel il travaille.Tous les salariés payés à l'heure ou à la semaine doivent recevoir, à compter du 1er décembre 1950, une augmentation de 7% sur leur taux en vigueur le 30 novembre 1950.Nonobstant les taux horaires minima du présent décret, tous les taux pour travail à la pièce en vigueur le 30 novembre 1950, doivent être majorés, de 7% à compter du 1er décembre 1950.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, \u2022 Québec, le 9 décembre 1950.» 28955-0 AVIS DE PRÉLÈVEMENT e L'honorable Antonio v Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des Services hospitaliers de la région de l'Est, de la Province de Québec, établi en exécution du décret numéro 3824 du 12 octobre 1944, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1316 du 30 novembre 1950, section \"B\", le tout conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective, à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret suivant la méthode et le taux ci-après: \u20221.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er décembre 1950 au 1er décembre 1951 ; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis\" par le décret numéro 3824 et ses amendements, doivent payer au comité paritaire une somme équivalente à }/2 de 1% des salaires, bonis ou allocations payés à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les salariés régis par ledit décret doivent payer au comité paritaire une somme équivalente à l/2 de 1% de leurs salaires, bonis ou allocations.after which time an apprentice shall be entitled to the full minimum provided for the respective craft in which such apprentice is actually performing work.\u2022 All apprenticeship in the crafts of full-skilled cutter, semi-skilled cutter and trimmer, must be completed at the end of the fourth year, irrespective as to whether or not such apprentice was employed in one or more of the aforementioned crafts consecutively or concurrently, after which time and apprentice shall be entitled to the full minimum herein provided for the respective craft in which such apprentice is actually performing work.All week or hourly workers shall receive on December 1st, 1950, an increase of 7% over their rates of pay prevailing on November 30, 1950.Notwithstanding the minimum rates per hour set forth in the present decree, all piece-work rates shall be increased on December 1st, 1950, by 7% over and above rates paid on November 30, 1950.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 9, 1950.28955-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Hospital Service Parity Committee for the Eastern District of the Province of Quebec, established under decree number 3824, of October 12th 1944, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 1316 of November 30, 1950, Part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act, to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereafter mentioned.1.Assessments The period of levy extends from December 1 1950, to December 1, 1951; such levy shall be laid as follows : a) The professional employers governed by the decree number 3824 and its amendments shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to of 1% of the wages, bonuses or allowances paid to their employees governed by the said decree.b) The employees governed by the said decree shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to 2^ of 1% of their wages, bonuses or allowances.2.Mode de perception Les cotisations sont payables mensuellement entre le 1er et le 10 de chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes dues au comité paritaire, à titre de prélèvement.~~ :¦ A chaque mois, l'employeur professionnel doit fournir au comité paritaire un rapport détaillé indiquant sur les formules mises à sa disposition par ledit comité paritaire, les nom, prénoms et 2.Method of collection The assessments are payable monthly between the 1st and the 10th day of each month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of every one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee.Every month, the professional employer shall submit to the Parity Committee a complete report, on forms supplied by the said committee, giving the name in full and address of every em- 3120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tomé 82, N° 49 adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail et le salaire payé.Ce rapport dûment signé par l'employeur professionnel doit être accompagné des cotisations payables au comité paritaire par ledit employeur professionnel et par ses salariés; toutes ces sommes doivent être payées en deniers ayant cours légal dans la province.Le comité paritaire a le droit d'exiger l'asser-mentation des rapports mensuels des employeurs professionnels chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier Selon les termes de la Loi de la convention collective, le comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministère du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des\" recettes et des.déboursés probables du Comité paritaire des Services Hospitaliers de la région de l'Est de la province de Québec, pour la période se terminant le 1er décembre 1951.hospitaliers de la region de l'est la province de québec Extimés budgétaires pour la période se terminant le 1er décembre 1951.Recettes : Cotisations de 1%) : Employeurs professionnels.$ 9,000.00 Salariés.9,000.00 $18,000.00 Déboursés : Salaires : Secrétariat.$ 8,000.00 Inspection.3,500.00 Loyer.'.1,000.00 Téléphone.300.00 Ameublement.200.00 Papeterie.,.600.00 Honoraires-Avocat.900.00 Frais légaux.100.00 Frais de voyages.1,100.00 Honoraires-Vérificateu r.100.00 Jetons de présence.1,500.00 Souscription à l'Université Laval.200.00 Dépenses contingentes.500.00 $18,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, lft 9 décembre 1950.28955-0 ployee in his employ, the latter's competency or classification, the number of regular or overtime hours worked each week, the nature of the work and the wages paid.The report, duly signed by the professional employer, shall be sent with the assessments payable to the Parity Committee by the said, professional employer and by his employees; all such assessments shall be paid with money that is current m this Province.The Parity Committee has the right to exact sworn monthly report from the professional employers every time it deems it advisable.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial activities on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Hospital Service Parity Committee for the Eastern District of the Province of Quebec, for the period ending December 1, 1951.The Hospital Service Parity Committee for the Eastern Part of the * Province of Quebec Estimated budget for the period, ending December 1, 1951.Receipts : e Assessments (J^ of 1%): Professional employers.$ 9,000.00 Employees.9,000.00 $18,000.00 Disbursements : Salaries: Secretary's office.$ 8,000.00 Inspection.3,500.00 Rent.1,000.00 Telephone.300.00 Furniture.p 200.00 Stationery.600.00 Legal adviser's fees.900.00 Legal charges.100.00 Travelling expenses.1,100.00 Auditor's fees.100.00 Meeting expenses.1,500.00 Subscription to Laval University- 200.00 Unforeseen expenses.500.00 $18,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 9, 1950.28955-0 Département du tréior Auurancea Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Treaiurery Department Iniurance Notice of Issue of License and Certificate of Registration Avis est donné par les présentes que \"Trans- Notice is hereby given that \"Transportation portation Insurance Company\", enregistré sous Insurance Company\" registered under number le numéro 507, a obtenu le permis et certificat 507 has obtained the license and certificate of d'enregistrement numéro 83 qui l'autorise, à registration number 83 authorizing it, as from compter du 9 octobre 1950, à effectuer dans la the 9th of October 1950, to undertake in the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3121 Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Accident; Maladie.Le siège social de la compagnie est situé à Chicago, État de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique.La compagnie a nommé M.P.-P.de la Bruère, 231 Ouest, rue St-Jacques, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, Département du Trésor, le 25 novembre 1950.Pour le Trésorier de la Province, GEORGES LAFRANCE, 28881-48-2-0 Surintendant des assurances.Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que \"Aluminum Company of Canada, Limited Shawinigan Works Employees' Mutual Benefit Association\", constituée en société de secours mutuels conformément aux dispositions de l'article 66 de la Loi des assurances, Chapitre 299, S.R.1941, et enregistrée sous le numéro 237, a obtenu le permis et certificat d'enregistrement N° 1063 qui l'autorise, à compter du 29 novembre 1950, à accorder à ses membres des bénéfices en cas d'accident et de maladie.Le siège social de la société est situé à Shawinigan Falls, province de Québec.Donné au bureau du Service des assurances, Département du Trésor, le 29 novembre 1950.Pour le Trésorier de la Province, GEORGES LAFRANCE, 2S892-48-2-o Surintendant des assurances.Province contracts of insurance of the following classes, Accident: Sickness.The head office of the company is situate at Chicago, State of Illinois, United States of America.The company has appointed Mr.P.P.de la Bruère, 231 St.James Street West, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Treasury Department, the 25th of.November 1950.For the Tresurer of the Province, GEORGES LAFRANCE, 28881-48-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Issue of Lecense and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"Aluminum Company of Canada, Limited Shawinigan Works Employees' Mutual Benefit Association\", incorporated as a mutual benefit association in accordance with the provisions of section 66 of the Quebec Insurance Act, Chapter 299, R.S.1941, and registered under number 237, has obtained the license and certificate of registration No.1063 authorizing it, as from the 29th of November 1950, to grant to its members accident and sickness benefits.The head office of the society is situate at Shawinigan Falls, Province of Quebec.Given at the office of the Insurance Branch, Treasury Department, the 29th of November 1950.For the Treasurer of the Province, GEORGES LAFRANCE, 28892-48-2-0 Superintendent of Insurance.Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DE HULL \u2014BAR OF HULL Candidat potjb l'admission a la pratique du droit Candidats for the admission- to the practice of law Examens de janvier 1951 \u2014 Examination* of January, 1951 Nom Name\tPrénom Surname\t\tAge\tRésidence Residence \tMassue .\t\t24\tOttawa.\t\t\t\t Hull, le 28 novembre 1950 \u2014 Hull, November 28, 1950.Le Secrétaire du Barreau de Hull, / R.MILLER1WALLACE, 28893-48-2-0 Secretary^ the Bar of Hull.BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OF LAURENTIDES Candidat pour l'admission a la pratique du droit Candidate for the admission to the practice of law Examens de janvier 1961 \u2014 Examinations of January, 1961 Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tResidence Residence Daviault.'.\t\t27\tBerthierville.\t\t\t Johette, le 28 novembre 1950 \u2014 Joliette, November 28th, 1950.Le Secrétaire du Barreau des Laurentides, MAURICE MAJEAU, 28893-48-2-o Secretary of the Bar of Laurentides. 3122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° Ifi BARREAU DE HULL \u2014BAR OF HULL Candidat pour l'admission a la pratique du droit Candidate for the admission to the -practice of law Examens de janvier 1951 \u2014 Examinations of January, 1951 Nom\tPrénom\t\tRésidence \u2014\t\u2014\tAgo\t\u2014 , Name\tSurname\t\tResidence \t\t24\tChapeau, P.Q.\t\t\t Hull, le 30 novembre 1950 \u2014 Hull, November 30, 1950.28058-49-2-o Le Secrétaire du Barreau do Hull, R.MILLER WALLACE, Secretary of the Bar of Hull.Greffes de Notaires Notarial Records Avis est par le présent donné conformément aux dispositions du Code du Notariat, qu'une requête a été présentée à la Chambre des Notaires par Me Bernard Cormier, notaire demeurant et exerçant à Belocil, district judiciaire de Montréal, par laquelle il demande la transmission en sa faveur des minutes, répertoire et index de Me A.M.Cormier et Me J.P.M.Bédard, notaires décédés.Montréal, 2 décembre 1950.Le Secrétaire-trésorier de la Chambre des Notaires, 28928-0 ' ARTHUR COURTOIS.Notice is hereby given pursuant to the provi sions of the Notarial Code, that a petition lias been presented to the Board of Notaries by Me Bernard Cormier, Notary residing and practising at Beloeil, Judicial District of Montreal, whereby he asks for the transfer in his favour of the minutes, repertory and index of Me A.M.Cormier and Me J.P.M.Bédard, deceased Notaries.Montreal, December 2nd, 1950.ARTHUR COURTOIS, Secretary-Treasurer of the Board 28928-0 of Notaries.Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, de nommer par lettres patentes sous le grand sceau de la province, au nom de Sa Majesté, les personnes dont les noms suivent, savoir Québec, 2 novembre 1950.M.W.H.Bradley, avocat, de la cité de Sherbrooke, et M.Renault St-Laurent, avocat, de la cité de Québec, tous deux membres du Barreau de la province: conseils en loi du Roi.\"28934-0 Appointments His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased with the advice and consent of the Executive Council, to appoint by letters patent under the Great Seal of the Province, in the name of His Majesty, the persons whose names follow, to wit: Quebec, November 2, 1050.Mr.W.II.Bradley, advocate, of the city of Sherbrooke, and Mr.Renault St-Laurent, advocate, of the city of Quebec, both members of the Bar of the Province: King's Counsel.28934 Proclamation Proclamation Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] GEORGE VI, par la grâce de Dieu, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, défenseur de la foi A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles .pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU QUE, sous général, < -f* l'autorité de l'article L.Désilets.13 de la Loi des palais de justice et prisons (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 31), le Heutenant-gouverneur peut, Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] GEORGE VI, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland andt he British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting.PROCLAMATION L.Désilets, / V\\/HEREAS under the auth Deputy Attorney < ority of section 3 of the General.(.Court House and Goal Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 31), the Lieutenant-Governor may, by proclamation, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.49 3123 par proclamation, lorsqu'il le juge convenable pour les fins de l'administration de la justice, ordonner que la prison commune d'un district soit également la prison commune et la maison de correction d'un autre district; Attendu que, sous l'autorité d'une proclama-lion en date du 3 décembre 1928, publiée dans la Gazette officielle de Québec le 7 décembre 1928, page 4180, les prisons établies dans les districts judiciaires alors existants ont été déclarées coni-junes les unes aux autres; Attendu que, depuis la publication de cette proclamation, de nouveaux districts judiciaires ont été organisés et qu'ils y a lieu de décréter qu'une proclamation soit émise pour ordonner que, dans la province, toute prison d'un district judiciaire soit déclarée la prison commune et la maison de correction d'un autre district judiciaire.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif, exprimés dans l'arrêté eu conseil No.1238 du 16 novembre 1950, et conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi des palais de justice et prisons (Statuts nl'ondus de Québec, 1941, chapitre 31), Nous a avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que toutes les prisons établies dans chacun des districts judiciaires d'Abitibi, d'Arthabaska, de Beauce, de Beau-harnois, de Bedford, de Bonaventure, de Chicoutimi, de Gaspé, de Hull, d'Iberville, de Joliette, de Kamouraska, de Labelle, de Montmagny, de Montréal, de Pontiac, de Québec, de Richelieu, de Rimouski, de Roberval ,de Rouyn^ Xoranda, de Sagucnay, de St-François, dè St-Hyacinthe, de Témiscamingue, de Terrebonne et de Trois-Rivières soient communes les unes aux autres.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: Témoins: Notre très fidèle et bieh-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP, LL.D., D.D.S., L.D.S., lieutenant-gouverneur de la province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre province de Québec, ce vingt-septième jour de novembre en l'année mil neuf cent cinquante de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatorzième.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 2S941-0 JEAN BRUCHÉSI.Sièges sociaux Canada, Province de Québec, District de Québec Dumais Frères Limitée Dumais Brothers Limited Avis de la Situation du Bureau Principal Avis est donné que la compagnie \"Dumais Frères Limitée\"\u2014\"Dumais Brothers Limited,\" constituée en corporation en date du vingt-huitième jour d'août 1950, et ayant son bureau principal dans la cité de Québec, a établi son bureau au Centre Industriel St-Malo.when he shall deem the same expedient for the purposes of the administration of Justice, order that the common gaol of a district shall be also the common gaol and house of correction of any other district; Whereas under the authority of a proclamation dated the 3rd day of December, 1928, published in the Quebec Official Gazette of the 7th of December, 1928, on page 4180, the gaols established in the judicial districts then existing were declared common one to the others; Whereas, since the publication of the said proclamation, new judicial districts have been organized and it is expedient to enact that a proclamation be issued to order that, in the Province, any gaol in a judicial district be declared the common gaol and house of correction of any other judicial district.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in the Order in Council No.1238 of the 16th of November, 1950, and pursuant to the provisions of section 3 of the Court House and Gaol Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 31), We have enacted and ordered and do hereby enact and order that all gaols extablished in each of the judicial districts of Abitibi, Arthabaska, Beauce, Beauharnois, Bedford, Bonaventure, Chicoutimi, Gaspé, Hull, Iberville, Joliette, Kamouraska, Labelle, Montmagny, Montreal, Pontiac, Quebec, Richelieu, Rimouski, Roberval, Rouyn-Noranda, Saguenay, St.Francis, St-Hyacinthe, Témiscamingue, Terrebonne and Trois-Rivières be common one to the others.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are, hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed, Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., DD.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this Twenty-seventh day of.November, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty and the fourteenth, year of Our Reign.By Command, .IEAN BRUCHÉSI, 28941 Under Secretary of the Province.Head Offices Canada, Province of Quebec, District of Quebec Dumais Frères Limitée Dumais Brothers Limited Notice of Situation of Head Office Notice is hereby given that tKe company \"Dumais Frères Limitée\"\u2014\"Dumais Brothers Limited\", incorporated under date the twenty-eighth day of August, 1950, and having its head office in the City of Quebec, has established its office at the \"Centre Industriel St-Malo\". 3124 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 A compter de la date du présent avis, le dit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Québec, ce septième jour de septembre 1950.Le Président, 28929-0 \u2022 DENIS DUMAIS.Province de Québec \u2014 District de Montréal Val Royal Building Materials Ltd.Matériaux de Construction Val Royal Ltée Avis est donné par les présentes que \"Val Royal Building Materials Ltd.\"\u2014\"Matériaux de Construction Val Royal Ltée\" compagnie constituée en corporation par lettres patentes en date du 7 septembre 1950, et ayant son siège social en la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 12100, blvd Reed* Montréal.A compter de la date du présent avis, ladite adresse sera considérée par la compagnie comme étant celle de son siège social.Daté à Montréal, Que., le 27 novembre 1950.Lé Président, 28930 L.C.CARROLL.\u2022 Dupresnoy Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) \\\u2014 Avis est donné par les présentes que \"Dupresnoy Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes émises le 27 mars 1944, ayant son siège social et sa principale place d'affaires, jusqu'à date de cet avis, à Duparquet, dans le canton de Duparquet, dans le district d'Abitibi, Québec, a transféré son siège social et sa principale place d'affaires à Chambre 3, no 180, 3ème avenue, en la ville de Noranda, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau, en la ville de Noranda, sera considéré par la compagnie comme étant son siège social et sa principale place d'affaires.Daté ce 24ème jour de novembre 1950.Dupresnoy Mines Limited, (Libre de responsabilité personnelle), Le Secrétaire, 28931 A.G.FULTON.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Quebec, this seventh day of September, 1950.DENIS DUMAIS, 28929 President.Province of Quebec \u2014 District of Montreal Val Royal Building Ma'serials Ltd.Matériaux de Construction Val Royal Ltée Notice is liereby given that \"Val Royal Building Materials Ltd.\"\u2014\"Matériaux de Construction Val Royal Ltée, a company incorporated by Letters Patent dated September 7, 1950, and having its Head Office in the City of Montreal, has established its office at number 12100 Reed Blvd., Montreal.From and after the date of the present notice, the said address will be considered by the Com- .pany as being that of its Head Office.Dated at Montreal, Que., this November 27, 1950.L.C.CARROLL, 28930-o ' President.Dupresnoy Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that \"Dupresnoy Mines- Limited\" (No Personal Liability) incorporated in the Province of Quebec by Letters Patent granted on the 27th day of March, 1944, having its head office and chief place of business up to the date of this notice at Duparquet, in the Township of Duparquet, in the District of Abitibi, Quebec, has moved its head office and chief place of business to Room 3, No.180, 3rd Avenue in the Town of Noranda, Quebec.From and after the date of this notice the said office at the Town of Noranda shall be considered by the Company as being the head office and chief place of business of the Company.Dated this 24th day of November, 1950: Dupresnoy Mines Limited, \u2022 (No Personal Liability), A.G.FULTON, 28931-o Secretary.Soumissions CORRECTION Ville de Mackayville (Comté de Chambly) Dans la Gazette officielle de Québec du 2 décembre 1950, à la page 3073, la date de l'ouverture des soumissions a été omise dans l'avis No.28875.La séance d'ouverture sera tenue le 18 décembre 1950, à 8.00 heures p.m.28918a-x-o CORRECTION .Commission scolaire catholique de Ditton (Comté de Compton) Tenders CORRECTION Town of Mackayville (County of Chambly) In the December 2nd, 1950 Edition of the Quebec Official Gazette, at page 3073, the date of opening of tenders was omitted in notice No.28875.The opening meeting will be held on December 18th, 1950, at 8.00 o'clock p.m.28918a-x-o CORRECTION Catholic School Commission of Ditton (County of Compton) On est prié de noter sur l'avis N° 28904 paru Please note that on notice No.28904 published dans La Gazette officielle de Québec du 2 décembre in the Quebec Official Gazette of December 2nd .QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, I960, Vol.82, No.Jfi 3125 1950, à la page 3069, que les obligations seront remboursables du 1er janvier 1952 au 1er janvier 1971.Les octrois sont payables de 1952 à 1956 inclusivement.28942-0 Vente \u2014 Loi de faillite Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure No.119.\"En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Gaston Rondeau, Garagiste, 2058 Sicard, Montréal.Cédant autorisé.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant savoir: Désignation \"Deux lots de terre ayant front sur la douzième Avenue dans le quartier Rosemont de la cité de Montréal, portant les numéros huit et neuf sur le plan de subdivision du lot originaire désigné par le numéro Cent soixante-dix-sept sur le plan et au livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la côte de la Visitation (Nos.177-8-9) avec garage, portant le No.civique 5363, 12e Avenue Rosemont.Ainsi que le tout se trouve présentement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées au dit immeuble.\" Sera vendu en vertu d'un jugement de la cour Supérieure (en faillite), rendu le 22 novembre 1950, à l'enchère publique conformément à.l'article 55, de la Loi de Faillite, de manière à donner à cette vente l'effet du décret au bureau du shérif du district de Montréal, Palais de Justice, Montréal, VENDREDI le 5 JANVIER 1951 à ONZE heures de Pavant-midi.Conditions : Comptant.En sus du prix d'acquisition, l'acquéreur devra payer les droits du gouvernement de 2J^% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges d'adresser au soussigné.Lé Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: Perras & Perras, Syndics-Licenciés, 4 est, rue Notre-Dame, Montréal.28899-48-2-o VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.HULL Cour Supérieure \u2014 District de Hull /\"pvONALD ST.LAURENT, gardien-N° 125.< U commis, des cité et district de (Hull, tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de son père, feu Joseph Octave St-Laurent, de son vivant des mêmes lieux, demandeur vs RENÉ EMMANUEL ST.LAU-.RENT, de la cité de New-York dans l'État de 1950, at page 3069, that the bonds are redeemable from January 1st, 1952 to January 1st, 1971.The grants are payable from 1952 to 1956 inclusively.28942-0 Sale \u2014 Bankruptcy Act Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.119.(Sitting in Bankruptcy).In the matter of: Gaston Rondeau, garage keeper, 2058 Sicard, Montreal, Authorized Assignor.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immovable, namely: Description Two lots of land fronting on Twelfth Avenue in Rosemount Ward of the City of Montreal, bearing numbers eight and nine on the subdivision plan of original lot described as number one hundred and seventy-seven on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village of Côte de la Visitation (Nos.177-8-9) with a garage, bearing civic No.5363, 12th Avenue, Rosemount.As the whole presently subsists, with the active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to the said immovable.To be sold In virtue of a judgment of the Superior Court (Sitting in Bankruptcy), rendered the 22nd day of November, 1950, by public auction pursuant to section 55 of the Bankruptcy Act.so as to give the said sale the effect of a Sheriff's sale, at the office of the Sheriff for the district of Montreal, Court House, Montreal, on FRIDAY, the FIFTH day of JANUARY, 1951, at ELEVEN o'clock in the forenoon., Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the purchaser must pay the Government fees of 2^% according to Law.For further information and list of charges, apply to the undersigned.CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of: Perras & Perras .Licensed Trustees, 4 Notre-Dame St.Dast, Montreal 28899-48-2 SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.HULL Superior Court \u2014 District of Hull (TNONALD ST.LAURENT, warden No.125.f-r and clerk, of the city and district (.of Hull, both personally and as heir to his father, the late Joseph Octave St.Laurent in his lifetime of the same place, plaintiff; vs RENE EMMANUEL ST, LAURENT, of the city of New York, in the^State of New York, one 3126 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 décembre 1950, Tome 82, N° 49 New-York, l'un des États-Unis d'Amérique; ARSENE ST.LAURENT, de la Cité de Détroit, dans l'état de / Michigan, l'un des États-Unis d'Amérique; JEANNE ST.LAURENT, épouse de,J.A.Major et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, tous deux de la cité d'Ottawa, dans la province d'Ontario, et Dame MARIE-ANGE CYR.veuve de Octave Provin St.Laurent de l'endroit appelé Cyrville, dans la province d'Ontario, tous tant personnellement qu'en leur qualité d'héritier de leur père ledit J.Octave St.Laurent, en son vivant des cité et district de Hull, défendeurs, et RODRI GUE BÉDARD, avocat et conseiller en loi du Roi, des cité et district de Hull, distrayant.1° Tout ce lot ou morceau de terre composé de la moitié Est du lot numéro soixante-quinze du cadastre pour le quartier numéro trois de la cité de Hull, borné comme suit: \u2014 En front vers le sud par la rue St.Etienne, vers l'est par la rue St.Henri, vers l'ouest par la moitié ouest du lot soixante-quinze et vers le nord par la ligne de division entre ledit lot soixante-quinze et le lot numéro soixante-huit du même quartier, ou par le terrain ci-après décrit; '2° Tout ce morceau de terre composé du quart sud-est du lot numéro soixante-huit dudit quartier numéro trois de la cité de Hull, borné comme suit: vers l'Est par la rue St.Henri, vers le nord par le quart nord-est dudit lot soixante-huit, vers l'Ouest par le quart sud-ouest dudit lot soixante-huit et vers le sud, par le terrain ci-dessus en premier lieu décrit.Les dits deux morceaux de terre mesurant ensemble quarante-huit pieds et demi dans les lignes nord et sud par quatre-vingt-dix-neuf pieds dans les lignes est et ouest, le tout plus ou moins, avec toutes les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Pour être vendus en bloc, au bureau du Shérif au Palais de justice, en la cité de Hull le 19 JANVIER 1951 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, I.ST-PIERRE Hull, le 5 décembre 1950.28953-49-2-0 [Première insertion: 9 décembre 1950] of the United States of America; ARSENK ST.LAURENT, of the city of Detroit, in the State of Michigan, one of the United States of America; JEANNE ST.LAURENT, wife of J.A.Major, and the latter to authorize his wife for the purposes hereof, both of the city of Ottawa, in the Province of Ontario, and Dame MARIE ANGE CYR, widow of Octave Provin St.Laurent, of the place called Cyrville, in the Province of Ontario, all both personally and as heirs to their father, the said J.Octave St.Laurent, in his lifetime of the city and'district of Hull, defendants; and RODRIGUE BÉDARD advocate and King's Counsel, of the city and district of Hull, distracting for costs.1.All that lot or parcel of land composed of the East half of lot number seventy-five on the cadastre for the Ward number three of the city < f Hull, bounded as follows: In front, towards the south by St.Etienne street, on the cast by St Henri street, on the west, by the west half of said lot seventy-five and on the north by the division line between said lot seventy five and lot number sixty-eight of the same ward, or by the lot of land hereinafter described; 2.All that parcel of land composed of the southeast quarter of lot number sixty-eight of said Ward number three of the city of Hull bounded as follows: towards the east by St.Henri street, towards the north by the northeast quarter .cf said lot sixty-eight, towards the west by the southwest quarter of said lot sixty-eight and towards the south by the lot of land above firstly described.These two parcels of land measure together forty-eight feet and one half in the north ami south lines by ninety-nine feet in the cast and west lines, the whole more or less, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold \"en bloc\" at the Sheriff's Office, in the Court House, in tlie city of Hull, on the _ NINETEENTH day of JANUARY, 1951, at TEN o'clock in the forenoon.I.ST-PIERRE, Sheriff's Office, Sheriff.Hull, December 5, 1950 28953-49-2 [First Insertion; December 9, 1950] MONTMAGNY Fieri Fàcias de Bonis et de Terris Cour du Magistrat District de Montmagny, /rPÉLESPHORE N° 15114.< A COULOMBE, (.négociant, de la ville de Montmagny, demandeur, vs PAUL-EMILE GIASSON, du quartier industriel, ville de Montmagny, district de Montmagny, défendeur.Une maison en bois construite sur un emplacement connu et désigné au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny partie annexée à la ville de Montmagny, comme étant partie du lot numéro soixante-et-onze (71) de onze cent soixante-neuf (1169) et partie du lot .jiuméro sept cent cinquante-sept (757) de onze cent soixante-neuf (11^69), ledit emplacement étant la propriété dudit Télesphore Coulombe.Pour être v»ndue à la porte de l'église de Saint-Thomas de Montmagny, le SEIZIÈME jour de JANVIER 1951, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du shérif, J.-ERNEST BERNIER.Montmagny, le 4 décembre 1950 28959-49-2-0 [Première insertion: 9 décembre 1950] MONTMAGNY Fieri Facias de Bonis et de Terris Magistrate's Court District of Montmagny /'TÉLESPHORE No.15114.-J 1 COULOMBE, (of the town of Montmagny, plaintiff vs PAUL-ÉMDLE GIASSON, industrial district, town of Montmagny, district of Montmagny, defendant.A wooden house situate on an emplacement known and designated upon the official cadastre of the parish of St-Thomas of Montmagny, being now annexed to the town of Montmagny, as a subdivision of lot number ^seventy-one (71) of eleven hundred and sixty-nine (1169) and subdivision of lot number seven hundred and fifty-seven (757) of eleven hundred and sixty-nine (1169), the said emplacement being the property of the said Télesphore Coulombe.To be sold, at the church door of St-Thomas of Montmagny, on the SIXTEENTH day of JANUARY 1951, at TEN o'clock of the forenoon.J.ERNEST BERNIER, Sheriff Office, Sheriff.December 4, 1950.28959-49-2-o [First insertion: December 9, 1950] QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 9th, 1950, Vol.82, No.1,9 3127 RIMOUSKI Canada, Province de Québec.Cour de Magistrat District de Rimouski, ( PHILIPPE LEFRAN-N° 21199.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.