Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 décembre 1950, samedi 30 (no 52)
[" Tomb 82, N° 52 3255 Vol.62, No.52 Drapeau de !\u2022 province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Ceo.VI, ce.I) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.I) Gazette officielle de Québec {PUBLIÉE par le GOUVERNEMENT Dt la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 30 décembre 1050\tQuebec, Saturday, December 30th, 1050 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlement*\tRule* 1° Adresser toute correspondance à: 1'Impri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party snail then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme without prejudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, Ja vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal money order.-» 7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Québec Officiai Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 3256 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 décembre 1960, Tome 88, N° 62 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la Etublication de certains documents, à cause de leur ongueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne.agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double., Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes :.$1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊOEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26489-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay-expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, ete.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The.first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our.translation.Notices published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439-1-52 Lettres patentes Agences Rama Agencies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a' été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1950, constituant en corporation: Cécile Marcoux Rousseau, ménagère, épouse con-tractuellement séparée de biens de J.-N.Rousseau et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Raymond Guilmette, marchand, et Robert Marchand, avocat, tous de Plessisville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Acheter, vendre et fabriquer des appareils, supports et chaussures orthopédiques, sous le nom de \"Agences Rama Agencies Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Plessisville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le six décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Letters Patent Agences Rama Agencies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1950, incorporating: Cécile Marcoux Rousseau, housewife, wife separate as to property by marriage contract of J.N.Rousseau and duly authorized by him for the purposes hereof Raymond Guilmette, merchant, and Robert Marchand, advocate, all of Plessisville, judicial district of Arthabaska, for tlic following purposes: To buy, sell and manufacture orthopaedic supports, accessories and shoes, under the name of \"Agences Rama Agencies Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Plessisville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3257 Automatic Dispensers Manufacturing Ltd.Automatic Dispensers Manufacturing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- vince de Québec des lettres patentes, en date du ince of Quebec, l>earing date the twenty-third vingt-trois novembre 1950, constituant en corpo- day of November, 1950, incorporating: Laurent ration: Laurent Desroches, avocat, Jacqueline Desroches, advocate, Jacqueline Laliberté, steno- Laliberté, sténographe, tous deux de la cité de grapher, both of the city of Montreal, and J.Montréal, et J.-Eloi Gervais, avocat, de Lon- Eloi Gervais, advocate, of LongueuU, all of the gueuil, tous du district judiciaire de Montréal, judicial district of Montreal, for the following pour les objets suivants: purposes: Exercer l'industrie de machinistes, manufac- To carry on the industry of machinists, and to turer, vendre, louer toutes espèces de vendeurs manufacture, sell and rent all kinds of automatic automatiques de marchandises, sous le nom de dispensers for merchandise, under the name of \"Automatic Dispensers Manufacturing Ltd.\", \"Automatic Dispensers Manufacturing Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 40,000 ac- with a capital stock of $40,000 divided into 40,000 tions de $1 chacune.shares of $1 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont-district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le vingt- Dated at the office of the Attorney Generd, trois novembre 1950.this twenty-third day of November, 1950.L'Assistant-procureur général, \u2022 L.DÊSILETS, 29048-o.L.DÊSILETS.29048 Deputy Attorney General.Ayers-Cliff Wood Products Limited Ayers-Cliff Wood Products Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- vince de Québec, des lettres patentes en date du ince of Quebec, bearing date the twenty-eighth vingt-huit novembre 1950, constituant en corpo- day of November, 1950, incorporating: Edward ration: Edward Binney Fairbanks, avocat, Al- Binney Fairbanks, advocate, Alfred Rowland feed Rowland A'Bear, administrateur, Rosse A'Bear, executive, Ross Thorburn Hoffman ins- Thorburn Hoffman, inspecteur, tous trois de pector, all three of the town of Mount Royal, Ville Mont-Royal, Dean Angus Watson, comp- Dean Angus Watson, accountant, and Emily table, et Emily Edith Macfarlane, secrétaire, Edith Macfarlane, secretary, both of the city of tous deux de la cité de Montréal, tous du dis- Montreal, all in the judicial district of Montreal, trict judiciaire de Montréal, pour les objets sui- for the following purposes: vante: Manufacturer, acheter, faire le commerce et To manufacture, buy, and deal in and with négocier des produits de bois de toutes sortes, wood products of all kinds, under the name of sous le nom de \"Ayers-Cliff Wood Products Li- \"Ayers-Cliff Wood Products Limited\", with a mited\", avec Un capital de $40,000 divisé en 2,500 capital stock of $40,000 divided into 2,500 corn-actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 mon shares of the par value of $10 each, and 1,500 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur preferred shares of the par value of $10.each, au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ayers- The head office of the company will be at Cliff, dans le canton de Stanstead, district judi- Ayers Cliff, in the township of Stanstead, judicial ciaire de St-Frençpis.district of St.Francis.Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General, huit novembre 1950.this twenty-eighth day of November, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÊSILETS, 29048 L.DÊSILETS.29048-o Deputy Attorney General.Ben Lewis Incorporated Ben Lewis Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I- of the tie de la Lei des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Aqt, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- vince de Québec, des lettres patentes en date du ince of Quebec, bearing date the fourteenth day quatorze novembre 1950, constituant en corpora- of November, 1950, incorporating: Ben Wiseberg, tion: Ben Wiseberg, manufacturier, d'Outremont, manufacturer, of Outremont, Jack Zimble, manu- Jack Zimble, manufacturier, et Samuel \"Stein, facturer, and Samuel Stein, advocate, both of the avocat, tous deux de la cité de Montréal, tous du city of Montreal, all in the judicial district of district judiciaire de Montréal, pour les objets Montreal, for the following purposes: suivants: Manufacturer et faire le commerce de hardes de To manufacture and deal in sportswear and sport et de vêtements en général, sous le nom de wearing apparel generally, under the name of \"Ben Lewis' Incorporated\", avec un capital de \"Ben Lewis Incorporated\", with a capital stock $60,000 divisé en 350 actions ordinaires de $100 of $60,000 divided into 350 common shares of chacune et 250 actions privilégiées de $100 cha- $100 each, and 250 preferred shares of $100 each, cune.Le nombre des actionnaires sera limité à vingt.That the number of its shareholders shall be limited to twenty.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont-district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal. 3258 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Daté du hureaudu Procureur général, le quatorze novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Brown Boveri Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-trtis novembre 1950, constituant en corporation: Ernest William Mockridgc, gérant, Clifford George Meek, teneur de livres, John Lawrence McCrory, Cecil Bruce Cooke, et Alfred Edward Liddell, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie immobilière et de placement sous le nom de \"Brown Boveri Realty Corporation\", avec un capital de §500,000, divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le nombre de ses actionnaires sera limité à vingt (20).lje siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Brownstcin Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre novembre 1950, constituant en corporation: Solly Brownstein, Moses Steinberg, et Saul Lehrer, tous marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et disposer de terrains, bâtisses et autres propriétés immobilières et droits réels, sous le nom de \"Brownstein Realties Inc.\" avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DESILETS.Capital Dress Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit novembre 1950, constituant en corporation: Max Gatis, manufacturier, Dame Ida Goldstein Gatis, manufacturière, épouse séparée de biens de Max Gatis, Peter Gatis, manufacturier, et Bernice Frank Gatis, ménagère, épouse séparée de biens de Peter Gatis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, négocier et faire le commerce de toutes sortes de vêtements, lainages, tissus, et tous ou chacun des autres articles de même nature, sous le nom de \"Capital Dress Limited\" avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions de $100 chacune.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Brown Bovcri Realty Corporation Notice is hereby given that under Pert I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: Ernest William Mockridgc, manager, Clifford George Meek, bookeeper, John Lawrence McCrory, Cecil Bruce Cooke, and Alfred Edward Liddell, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and real estate company, under the name of \"Brown Boveri Realty Corporation\", with a capital stock of $500,000, divided into 5,000 shares of the par value of 8100.each.The number of its sliareholders shall be limited to twenty (20).The head office of the Company will be at Montreal, Judicial Distiict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Brownstein Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-fourth day of November, 1950, incorporating: Solly Brownstein, Moses Steinberg, and Saul Lchrer, all merchants of the City and .Judicial District of Montreal, for the following purposes: To acquire and dispose of lands, buildings or other immoveable property and real rights, under the name of \"Brownstcin Realties Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fourth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Capital Dress Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1950, incorporating: Max Gatis, manufacturer, Dame Ida Goldstein Gatis, manufacturer, wife separate as to property of Max Gatis, Peter Gatis, manufacturer, and Bernice Frank Gatis, housewife, wife separate as to property of Peter Gatis, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, trade and deal in all kinds of wearing apparel, woollens, fabrics and all or any other articles of the same nature, under the name of \"Capital Dress Limited\", with a capital stock of $75,000 divided into 750 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December SOtk, 1960, Vol.82, No.62 3259 Le siège sociul de la compagnie sera à Montréal, distiict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 20048 L.DÊSILETS.Century Stainless Steel Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Liicutcnant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1950, constituant en corporation: Gilles Théberge, gérant, François Fabi, entrepreneur, et Eugène Lafleur, agronome, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exploiter le commerce et la vente d'effets et ustensiles de cuisine, sous le nom de \"Century Stainless Steel Company Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Chap and Ma Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1950, constituant en corporation: Orner Chapdelainc, Etienne Chap-delaine, cultivateurs, de St-Ours, district judi ciaire de Richelieu, Jules Morin, docteur en médecine, de Saint-Hyacinthe et Charles-Emile Marion, cantonnier, de Saint-Barnabé, ces deux derniers du district judiciaire de Saint-Hyacinthe pour les objets suivants: Faire et exercer tous commerces comme en-preneurs pour la construction, l'érection, réparation, modification, maintien et ou opération de travaux publics ou privés de toute nature ou genre quelconque, sous le nom de \"Chap and Ma Construction Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Ours, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 259048-o L.DÊSILETS.Chavigny Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies Minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du trente novembre 1950, constituant en corporation: Joseph-Adelbert Demers, agent d'affaires, de Ville Jacques-Cartier, Joseph Rioux, agent d'affaires, et Joseph-P.-M.Lalancette, manufacturier, ces deux derniers de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais; The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Century Stainless Steel Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: Gilles Théberge, manager, François Fabi, contractor, and Eugène Lafleur, agronomist, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To deal in and sell kitchen effects and utensils, under the name of \"Century Stainless Steel Company Limited\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Chap and Ma Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1950, incorporating: Omcr Chapdelainc, Etienne Chap-delaine, farmers, of St-Ours, judicial district of Richelieu, Jules Morin, doctor of medicine, of Saint-Hyacinthe, and Charles Emile Marion, section-man, of Saint-Barnabé these two latter of the judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on an engage in all industries as contractors for the building, erecting, repairing, altering, maintaining and operating of works, public or private, of any nature whatsoever, under the name of \"Chap and Ma Construction Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Ours, judicial district of 'Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Chavigny Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of November, 1950, incorporating: Joseph Adelbert Demers, business agent, of the Town of Jacques-Cartier, Joseph Laurent Rioux, business agent, and Joseph P.N.Lalancette, manufacturer, these two latters of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals; 3260 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charriei, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer, ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d'en extraire les minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelques procédés que ce soit; les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Chavigny Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital de $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle ou au delà du montant ou du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions; Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.To carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may for the purpose of extracting any minerals whatsoever, l>c mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Chavigny Mines Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4,000,000 divided into 4,000,000 shares of ?1 each.The shareholders shall incur no personal liability in excess of the amount paid or agreed to be paid to the company for its shares; The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Club de Baseball Saint-Jean Limitée Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1950, constituant en corporation: Maurice Faraud, agent, de la paroisse de Saint-Jean, Harolde Savoy, industriel.Henri Lai lamine, médecin, tous deux de la ville d'Iber-ville, Edgar Gaudette, ingénieur civil, Roland Sabourin, avocat, Roger Lanoue, gérant, Philippe Trahan, marchand, Gaston Poutre, hôtelier, et Laurent McMillan, comptable, tous de la cité de Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: Promouvoir, opérer et établir des organisations sportives, et en particulier le jeu de baseball sous le nom de \"Club de Baseball Saint-Jean Limitée\", avec un capital de $49,000 divisé en 490 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire dTberville.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Clubs Juvéniles du Comté de Drummond Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq novembre 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Raymond Jacques, employé d'usine, Léandre Marcil, marchand, et Raymond Lalonde, contremaître, tous de Drummond ville, distiict judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Grouper, réunir, organiser et diriger des membres dans le but de les intéresser individuellement et collectivement au bien-être et à la culture morale, intellectuelle et physique des enfants et de promouvoir la prévention de la criminalité juvénile, sous le nom de \"Clubs Juvéniles du comté de Drummond Inc.\" Les pouvoirs accordés n'autorisent pas la corporation à demander et à exploiter des permis ou licences ordinairement octroyés par la commission des liqueurs de Québec, et ne doivent pas être interprétés comme permettant les jeux à l'argent, les jeux de hasard et les jeux mixtes de ha- Club de Baseball Saint-Jean Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Queliec, bearing date the twenty-eighth day of Novemlier, 1950, incorporating: Maurice Farand, agent, of the parish of Saint Johns, Harolde Savoy, industrialist, Henri Laflamme, physician, both of the town of Iberville, Edgar Gaudette, civil engineer, Roland Sabourin, advocate, Roger Lanoue, manager, Philippe Trahan, merchant, Gaston Poutre, hotel keeper, and Laurent McMillan, accountant, all of the city of St-Johns, judicial district of Iberville, for the following purposes: To promote, operate and establish sports organizations, and m particular the game of base -ball, under the name of \"Club de Baseball Saint-Jean Limitée\", with a capital stock of $49,000 divided into 490 shares of $100 each.The head office of the company will be at St.Johns, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1950.* L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Clubs Juvéniles du Comté de Drummond Inc.Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of November, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Raymond Jacques, plant employee, Léandre Marcil, merchant, and Raymond Lalonde, foreman, all of Drummondville, judicial district of Arthabaska.for the following purposes: To group together, assemble, organize and direct the members for the purpose of interesting them individually and collectively in the welfare, the moral, intellectual and physical culture of children and to encourage the prevention of juvenile delinquency, under the name of \"Clubs Juveniles du Comté de Drummond Inc.\" The powers conferred do not authorize the corporation to apply for and operate permits or licenses granted by the Quebec Liquor Commission, and shall not be interpreted as permitting gambling, games of chance and games of chance and skill mixed, if played under the conditions QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December SOth, 1950, Vol.82, No.52 3261 sard et d'habileté, s'ils sont joués dans des conditions telles qu'ils viennent en contravention avec le Code Criminel du Canada; Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Drum-mi)i id vil le, distiict judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS that constitute a contravention of the Criminal Code of Canada; The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is §25,000.The head office of the corporation will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.C.Roland Champcau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec tics lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1950, constituant en corporation: C.-Roland Champcau, Ben Steinberg, marchands, et Charles-Ed.Bissionnette, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme vendeurs dans les matelas et des textiles, linoleums, dans les tuiles d'asphalte et de caoutchouc; et tous articles de vêtements, sous le nom de \"C.Roland Champcau Ltée\", avec un capital de $75,000 divisé en 7,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Eastern Containers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept novembre 1950, constituant en corporation: Jack Katz, marchand, Edward S.Berger, avocat, Benjamin L.Louis, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, vendre, distribuer, nettoyer, réparer, rénover les barriques d'acier, tonneaux et contenants de toute description, sous le nom de \"Eastern Containers Ltd.\" avec un capital de $40,000, divisé en 2,000 action ordinaires de $10 chacune et 2, 000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont-tréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Exclusive Silks Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-trois novembre 1950, constituant en corporation: Harry H.Hockenstein, marchand Dame Rose Marinoff Hockenstein, épouse séparée de biens de Harry H.Hockenstein et Philip S.Garcnce, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou chacun des commerces de fra-biicants de vêtements,rtailleurs, drapiers, bonnetiers, modistes costumiers, chapeliers, gantiers, C.Roland Champeau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1950, incorporating: C.Roland Champeau, Ben Steinberg, merchants, and Charles Ed.Bissonnettes, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as vendors of mattresses and textiles, linoleum, asphalt and rubber tiles; and all articles of clothing, under the name of \"C.Roland Champcau Ltée\", with a capital stock of $75,000 divided into 7,500 shares of SI0 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.I asi» in Containers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seven-ieenth day of November, 1950, incorporating: Jack Katz, merchant, Edward S.Berger, advocate, Benjamin L.Louis, advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: ; To manufacture, sell, distribute, clean, repair, recondition steel barrels, drums, and containers of all description, under the name of \"Eastern Containers Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 2,000 common shares of $10 each, and 2,000 preferred shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Exclusive Silks Inc.Notice is hereby given that under Parti of the Quebec Compagnies' Act, letters patent have been issued by the Lieu tenant-Gou vernor of the province of Quelle, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: Harry H.Hockenstein, merchant, Dame Rose Marinoff Hockenstein, wife separate as to property of Han y H.Hockenstein, and Philip S.Garoncc, advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on all or any of the business of clothiers, tailors, drapers, hosiers, milliners, costumiers, hatters, glovers, furriers, silks, carpets, 3262 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 décembre 1950, Tome 82, N° 52 fourreurs, marchands de hardes, sous le nom de \"Exclusive Silks Inc.\" avec un capital de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1031 rue Mont Royal, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Grovedale Construction and Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt novembre 1950, constituant en corporation: Samuel David Gameroff, entrepreneur, Ruth Clark, ménagère, épouse séparée de biens dudit Samuel David Gameroff, tous deux de la cité d'Outremont, et Louis Gameroff marchand, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeur et d'en-preneurs et exploiter une agence générale de l'immeuble, sous le nom de \"Grovedale Construction and Realty Co.Ltd.\", avec un capital de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, et 300 actions priviligiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Hector Investments Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt novembre 1950, constituant en corporation: John Fitzwilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans et Albert Bronson, Culver, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Hector Investment Limited\".Le capital actions de la compagnie est divisé en 98,000 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant de capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $490,000.\u2022 ^ Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Humane Society of Deschênes Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit novembre 1950, constituant en corporation sans capital actions: Lionel Mougeot, avocat, Pierre Fortier, comptable agréé, et R.Miller Wallace, C.R., avocat, tous de Hull, district judiciaire de Hull, pour les objets suivants; cotton, cloth and lace merchants, wearing apparel merchants, under the name of \"Exclusive Silks Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 300 common shares of $100.each, and 100 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at 1031 Mount Royal Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Grovedale Construction and Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Compagnies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-gouvernor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1950, incorporating: Samuel David Gameroff, conti actor, Ruth Clark, housewife, wife separate as to property from the said Samuel David Gamcoff, both of the City of Outremont, and Louis Gameroff, merchant, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of builders and contractors, and do a general real estate agency business, under the name of \"Grovedale Construction and Realty Co.Ltd.\", with a capital stock of $50,000.divided into 200 common shares of a par value of $100.each, and 300 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at La-chine, in the Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Hector Investments Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1950, incorporating: John Fitzwilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans and Albert Bronson Culver, all advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Hector Investments Limited\".The capital stock of the company is divided into 98,000 shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its opérations will be $490,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Humane Society of Deschênes Notice is hereby given that under the provisions of Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1950, incorporating without share capital : Lionel Mougeot, barrister, Pierre Fortier, chartered accont-ant, and R.Miller Wallace, K.C., barrister, all of Hull, judicial district of Mull, for the following purposes; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December SOth, 1950, Vol.82, No.52 3263 Promouvoir et développer les sentiments humanitaires et pourvoir des moyens efficaces d'empêcher la cruauté envers les animaux et les oiseaux, sous le nom de \"Humane Society of Deschênes\".Le montant auquel est limité la valeur des biens immobiliers que la corporation pourra posséder est de $25,000.Le siège social delà corporation sera à Deschênes, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.To promote and develop public humane sentiment and to provide effective means for the preventions of cruelty to animals and birds, under the name of \"Humane Society of Deschênes\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $25,000.The head office of the Corporation will be at Deschênes, Judicial District of Hull.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Imanuel Langer Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Xieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-trois novembre 1950, constituant en corporation: David Finestone, comptable agréé, David L.Cahana, avocat, tcus deux de la cité de Montréal, et Louis Glazer, avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses branches un commerce général de fourrure et de cuir, sous le nom de \"Imanuel Langer Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Imanuel Langer Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: David Finestone, chartered accountant, David L.Cahana, advocate, both of the City of Montreal, and, Louis Glazer, advocate, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on a general fur and leather business in all its branches, under the name of \"Imanuel Langer Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the Office of the Attorney General this twenty-third day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.J.A.Poissant et Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept novembre 1950, constituant en corporation: André Martin, avocat, de Westmount, Gisèle Dagenais, secrétaire, de la cité de Verdun et Jean-Paul Lavallée, avocat, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme couvreurs, entrepreneurs-couvreurs, ferblantiers, entrepreneurs en ventilation, sous le nom de \"J.A.Poissant et Fils Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.J.A.St.Laurent Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partk de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit novembre 1950, constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en loi, Clifford George Meek, et Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: J.A.Poissant et Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the \u2022Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of November, 1950, incorporating: André Martin, advocate, of Westmount, Gisèle Dagenais, secretary, of the city of Verdun, and Jean Paul Lavallée, advocate, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as roofers, roofing contractors, tinsmiths and ventilation contractors, under the name of \"J.A.Poissant et Fils Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The number of shareholders of the company will he limited to twenty.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.J.A.St.Laurent Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1950, incorporating: William Patrick Creagh, law Clerk, Clifford George Meek, and Guy Ambrose Miller, bookkeepers, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: 3264 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Exercer le commerce général de garagiste et camionneurs, sous le nom de \"J.A.St.Laurent Limited\", avec un capital de $250,000,divisé en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.To carry on the business of general garage-men and truckers, under the name of \"J.A.St.Laurent Limited\", with a capital stock of $250,000.divided into 2,000 preferred shares of the par value of 8100 each, and 500 common shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-Ô Deputy Attorney General.Jos.Dupuy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1950, constituant en corporation: Almanzor Labcrge, comptable, de Montréal, Contran Daoust, comptable, de St-Vincent-de-Paul, et Andrée Lavoic, secrétaire, de Rosemont, sus du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois, de rebuts de bois, sous le nom de \"Jos Dupuy Inc.\", avec un capital de $200,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune et en 1,000 actions piivilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Les Autobus Boulais Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1950, constituant en cor-ration: Arsène Boulais, propriétaire d'autobus, Dame Aurore Tremblay, ménagère, et Stanislas Déry, avocat, tous se Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: Exercer les poérations d'opérateurs d'autobus ou autre moyen de locomotion, sous le nom de \"Les Autobus Boulais Limitée\", avec un capital de $70,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune, et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DESILETS.Loup's Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt novembre 1950, constituant en corporation: Robert Tracey, marchand, de Verdun, Alec One-son, marchand, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, et William Alexander Barnes, gérant, de Halmilton, Ontario, pour les objets suivants: Jos.Dupuy Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, -4950, incorporating: Almanzor Laberge, accountant, of Montreal.Contran Daoust, accountant, of Saint-Vincent-de-Paul, and Andrée La voie, secretary, of Rose-mount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: ' To deal in lumber and waste wood, under the name of \"Jos.Dupuv Inc.\", with a capital stock of $200,000 divided into 1,000 common shares of $100 each and 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be in the Town of Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Les Autobus Boulais Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Compagnies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Gouvernor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fourth day of November, 1950, iincorporating: Arsène Boulais, autobus proprietor, Dame Am ore Tremblay, housewife, and Stanislas Déry, advocate, all of Saint Johns, judicial district of Iberville, for the following purposes: To carry on the business \"of autobus operators and operators of other means of transportations under the name of \"Les Autobus Boulais Limitée\", with a capital stock of $70,000 divided into 200 common shares of $100 each, and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint Johns, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.' Loup's Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1950, incorporating: Robert Tracey, merchant, of Verdun, Alec Oneson, merchant, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, and William- Alexander.Barnes, manager, of Hamilton, Ontario, for tin-following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3265 Eercer un commerce général de tenanciers de restaurant et de confiseurs, sous le nom de \"Loup's Inc.\", avec un capital de $40,000.divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DESILETS.L.Young Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt novembre 1950, constituant en corporation: Louis Young, manufacturier, Lillian Lazare, secrétaire, tous deux d'Outremont, et Samuel Stein, avocat, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous vêtements quelconques, sous le nom de \"L.Young Sportswear Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Marc Motor Cars & Repairs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept octobre 1950.constituant en corporation: Marcel La jeunesse, avocat, Alcide Gre-non, comptable, Jeanne Gauthier, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, faits, en tout ou en partie, de cuir caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, produits et sous-produits du pétrole, combustible de tout genre et de toute description, appareils de chauffage de toute genre et de toute description, véhicules moteurs et accessoires, sous le nom de \"Marc Motor Cars & Repairs Ltd.\".Le capital actions de la compagnie est divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $500.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept octobre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Michel Rodin Inc.Avis est donnê*\"qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provnice de Québec, des lettres patentes en date Generally to carry on the business of restaurant keepers and confectioners, under the name of \"Loup's Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 shares of $100.each, and 200 preferred shares of $100.each.The head affice of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.L.Young Sportswear Inc.Notice is hereby given that under Part I.of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1950, incorporating: Louis Young manufacturer, Lillian Lazare, secretary, both of Outremont, and Samuel Stein, advocate, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel of every description whatsoever, under the name of \"L.Young Sportswear Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 100 common shares of $100.each, and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Marc Motor Cars & Repairs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of October, 1950, incorporating: Marcel Lajeunesse, advocate, Alcide Grenon, accountant, Jeanne Gauthier, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of products, made in whole or in part of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, petroleum products and byproducts fuel of all kinds and description, heating apparatus of all kinds and description, motor-cars, and accessories, under the name of \"Marc Motor Cars & Repairs Ltd.\".The capital stock of the company is divided into 100 shares having no nominal or par valu, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $500.The number of shareholders shall l)e restricted to-not more than twenty.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth cay of October, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Michel Rodin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing**date the twentieth 3266 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 du vingt-novembre 1950, constituant en corporation: David Miller, marchand, Hynian Singerman, agent, Albert Rabinovitch, vendeur, et Mildred Rodin, gérante, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce qui consiste à établir et opérer des studios de danse, sous le nom de \"Michel Rodin Inc.\" avec un capital de 840,000 divisé en 60 actions ordinaires de $100 chacune et 340 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.' day of November, 1950, incorporating: David Miller, merchant, Hyman Singerman, agent, Albert Rabinovitch, salesman, and Mildred Rodin, manager, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of establishing and operating dance studios, under the name of \"Michel Rodin Inc.\" with a capital stock of $40,000.divided into 60 common shares of $100 each, and 340 preferred shares of $100.eah.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General twentieth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General.Midway Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt novembre 1950, constituant en corporation: Irving Bromberg, manufacturier, Leo Roscntzveig, avocat, Alice Axelrod, secrétaires, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces de manufacturier et négociant de toutes espèces de chapeaux, nouveautés, vêtements et textiles de toutes sortes, sous le nom de \"Midway Industries Ltd.\", avec un capital de $30,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procurer général, le vingt novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Midway Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1950, incorporating: Irving Brombcrg, manufacturer, Leo Rosentz-veig, advocate, Alice Axelrod, secretary, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry On the businesses of manufacturers and in all kinds of headwear, novelties, wearing apparel and textiles of all kinds, under the name of \"Midway Industries Ltd.\", with a capital stock of $30,000.divided into 1,000 common shares of $10.each, and 2,000 preferred shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicij 1 District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of November, 1950.L.DÊSTLETS, 29048-o Deputy Attorney General.Nordic Oil Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du vingt-deux novembre 1950, constituant en corporation: Roland Gagnon, Marcel Gagnon et Fernand Gagnon, garagistes, de Saint-Féliçien, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Faire le commerce dans toutes les sortes d'au-mobiles, moteurs, accessoires, huiles et gazoli-ne de tous genres; et le commerce de garagiste en général, sous le nom de \"Nordic Oil Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Omega Electric Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept novembre 1950, constituant en corporation: Jan Rudolf Cekal, manufacturier, Harry Blank, avocat, Jumen Wildstein, vendeur, et Nordic Oil Ltd.Notice is-hereby given that under Part I the Quel>ec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutcnant-Gouvernor of the Pro vincc of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1950, incorporating: Roland Gagnon, Marcel Gagnon and Fernand Gagnon, garage keepers, of Saint-Félicien, judicial district of Robetval, for the following purposes: To deal in all kinds of automobiles, motors, accesories, oil ans gazoline'of all kinds; and carry on the business of garage keeper in general, under the name of \"Nordic Oil Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 dhares of $100 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Omega Electric Co.Ltd.Notice is hereby given thet under Part I of the Quebec Compagnies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of November, 1950, incorporating: Jan Rudolf Cekal, manufacturer, Harry Blank, advocate, Jumen Wildstein, salesmen, and Samuel Godinsky QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 80th, 1950, Vol.82, No.62 3267 Samuel Godinsky, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs de plom-rie, chauffage et réfrigération et installer des gic-cleurs et appareils d'air climatisé, 'sous le nom de \"Omega Electric Co.Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Ix; siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.Pcpin & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1950, constituant en corporation: J.-Raymond Dcmers, agent d'immeuble, Pierre Jutras, avocat, et Stephen Ling, commis de bureau, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits agricoles et tous les autres produits manufacturé provenant du grain, des céréales et d'autres moulée agricoles et semences de toutes sortes, sous le noms de \"Pépin & Fils Limitée\", avec un capital de S80,000, divisé en 2,000 actions communes de S10 chacune et en 600 actions de $100 chacune.\u2022Le siège social de la compagnie sera à Warwick, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.P.M.Cinq-Mars Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quatre décembre 1950, constituant en corporation: Pierre Cinq-Mars, gérant, Dame Olympia Devito-Cinq-Mars, ménagère, tous deux de Pointe-Claire, et Marc Cinq-Mars, architecte, de Longucuil, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Agir comme agents et courtiers pour le placement, le paiement et la transmission d'argent, sous le nom de \"P.M.Cinq-Mars Inc,\", avec un capital de $39,500, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et en 345 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune: Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatre décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o .L.DÊSILETS.P.P.Masson Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1950, constituant en advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and refrigeration contractors and to install sprinklers and air-conditioning equipment, under the name of \"Omega Electric Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal-, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048-o Deputy Attorney General* Pepin & Fils Limitée i Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: J.Raymond Deniers, real estate agent, Pierre Jutras, advocate, and Stephen Ling, office clerk, all of Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To deal in agricultural products and in all other manufactured products derived from grain, cereals or in other farm meal and seed grain of all kinds, under the name of \"Pepin & Fils Limitée\", with a capital stock of $80,000, divided into 2,000 common shares of $10 each .and 600 shares of $100 each.The head office of the company will be at Warwick, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 DeputyAttorney General.P.M.Cinq-Mars Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day, of December, 1950, incorporating: Pierre Cinq-Mars, manager.Dame Olympia Devito-Cinq-Mars, housewife, both of Pointe-Claire, and Marc Cinq-Mars, architect, of Longueuil, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To act as agents and brokers for the investment, payment and transfer of money, under the name of \"P.M.Cinq-Mars Inc.\", with a capital stock of $39,500 divided into 500 common shares of a par value of $10 each, and 345 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.P.P.Masson Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1950, incorporating: 3268 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 corporation: Pacifique-P.Masson, commerçant René Masson, comptable, et Albert Masson, voyageur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et généralement faire le commerce de toutes fournitures, des machineries, d'outils, de comptoirs, de balances ou autres articles en usage dans les étaux de boucheries et d'épiceries, sous le nom de \"P.P.Masson Limitée\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.lie siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux novembre 1950.L'Assistant-procureur général.29048-o L.DESILETS.Pacifique P.Masson, merchant, René Masson, accountant, and Albert Masson, traveller, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal generally in all kinds of equipment, machinery, tools, counters, scales or other articles used in butcher stalls and grocery shops, under the name of \"P.P.Masson Limitée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 \"Deputy Attorney General.Precision Panels Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-et-un novembre 1950, constituant en corporation: L.-E.Langis Galipeault, Jacques Galipeault, avocats, et conseil en loi du Roi, et Antonio Leclerc, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses branches le commerce de manufacturier et marchand de billes bois de construction, bois de charpente, produits ou sous-produits du bois et de la pulpe, sous le nom de \"Precision Panels Inc.\", avec\" un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Ba-sile, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-et-un novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048 L.DÊSILETS.i Precision Panels Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of November, 1950, incorporating: L.-E.Langis Galipeault, Jacques Galipeault, advocates and King's Counsel, and Antonio Leclerc, accountant, all of the City and Judicial District of Quebec, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of a manufacturer of and dealer in logs, lumber, timber, products or by-products of wood and pulp, unde** the name of \"Precision Panels Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at St.Basile, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of November, 1950.L.DÊSILETS, «29048-o Deputy Attorney General.Preferred Sportswear Manufacturers' Inc.Preferred Sportswear Manufacturers' Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par- ¦ Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- vince de Québec, des lettres patentes en date du ince of Quebec bearing date the sixteenth day of seize novembre 1950, constituant en corporation: November, 1950, incorporating: Jack Friedman, Jack Friedman, manufacturier, Lipa Fleising, ma- manufacturer, Lipa Fleising, manufacturer, and nufacturier, et Alter Pasternak, manufacturier, Alter Pasternak, manufacturer, of the city and des cité et district judiciaire de Montréal, pour les judicial district of Montreal, for the following objets suivants: purposes: Exercer le commerce et le négoce de manufac- To carry on and engage in the business of cloth- turiers de vêtements, tailleurs, marchand de nou- ing manufacturers, tailors, drapers, hosiers, mil- veautés, bonnetiers, modistes, costumiers, chape- liners, costumers, hatters, furriers, glovers, Hers, fourreurs, gantiers, et confectionneurs en haberdashers and general outfitters, under the général, sous !e nom de \"Preferred Sportswear name of \"Preferred Sportswear Manufacturers Manufacturers Inc.\", avec un capital de $20,000 Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided divisé en 200 actions de $100 chacune.into 200 shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont-district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize Dated at the office of the Attorney General, novembre 1950.this sixteenth day of November, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉ.SILETS, 29048 L.DÉSDLETS.29048-o Deputy Attorney General.Quebec Editions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1950, constituant en corporation: Emé Lacroix, C.R., avocat, de ville Quebec Editions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1950, incorporating: Emé Lacroix, K.C., advocate, of the town of Mount QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3269 Mont-Royal, Lucien Thouin, avocat, et Marcelle Langlois, sténographe, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Pratiquer l'industrie et faire le commerce d'imprimerie généralement, de lithographie, de photogravure, sous le nom de \"Quebec Editions Inc.\", avec un capital de $-10,000 divisé en 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune, et 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.Royal, Lucien Thouin, advocate, and Marcelle Langlois, stenographer, both of the city of Montreal, for the following purposes: To practice the printing trade in general, and carry on the business of printing, lithography and photo-engraving, under the name of \"Quebec Editions Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 3,500 preferred shares of a par value of $10 each, and 5,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.Rodrigue Lasnier Automobile Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre, 1950, constituant en corporation: Rodrigue Lasnier, agent, Dame Fernande Bourdeau, épouse séparée de biens de Rodrigue Lasnier, tous deux de la ville d'Iber-ille, et Luc Lasnier, gérant, de la ville de St-Jean, tous du district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de garagiste, et faire le commerce en gros ou en détail de réfrigérateurs, automobiles ou tout autre genre de véhicules, sous le nom de \"Rodrigue Lasnier Automobile Limitée\", avec un capital de $149,000 divisé en 990 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le nombre des actionnaires, non compris les employés de la compagnie, sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.St-John Café Incorporated Café St-Jean Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre novembre 1950, constituant en corporation: Joseph-Melchior Latendresse, marchand, Jean-Baptiste Latendresse, et Joseph-Charles-Médard Latendresse,' commerçants, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le\" commerce d'hôtel, avec tous les privilèges attachés à ce genre de commerce, sous le nom de \"St-John Café Incorporated\"\u2014\"Café St-Jean Incorporée\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions de $100 chacune.Les pouvoirs ci-dessus ne pourront pas être interprétés comme permettant les jeux à l'argent, les jeux de hasard et les jeux mixtes de hasard et d'habileté.Le siège social de la compagnie sera au numéro 984, rue St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Rodrigue Lasnier Automobile Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: Rodrigue Lasnier, agent, Dame Fernande Bourdeau, wife separate as to property of Rodrigue Lasnier, both of the town of Iberville, and Luc Lasnier, manager, of the City of St.Johns, all of the judicial district of Iberville, for the following purposes: To carry on the business of garage keeper, and to deal, wholesale and retail, in refrigerators, automobiles or any other kind of véhicules, under the name of.\"Rodrigue Lasnier, Automobile Limitée\", with a capital stock of $149,000 divided into 990 common shares of a par value of $100 each and 500 preferred shares of a par value of $100 each.The number of shareholders, not including employees of the company, will be limited to twenty.The head office of the company will be at St.Johns, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29048 Deputy Attorney General.St-John Café Incorporated Café St-Jean Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1950, incorporating: Joseph Melchior Latendresse, merchant, Jean Baptiste Latendresse, and Joseph Charles Mellaril Latendresse, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the hotel business, with all the privileges attaching to such business, under the name of \"St-John Café Incorporated\"\u2014 \"Café St-Jean Incorporée\", with a capital stock of $30,000 divided into 300 shares of $100 each.The foregoing powers shall not be interpreted as permitting gambling, games of chance and games of chance and skill mixed.The head office of the company will be at No.984 St-Laurent street, Montreal, judicial district of Montreal. 3270 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre novembre 1950.% L'Assistant-procureur général, 29048-o L.DÊSILETS.St.Régis Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en Vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt novembre 1950, constituant en corporation: Henri Crépeau, avocat et conseil en loi du Roi, Françoise Gagnon et Yvette Picard, toutes deux secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, .charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter par quelque moyen que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierrres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit, et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"St.Regis Mines Limited\", (Libre de responsabilité personnelle) avec un capital de $3,000,000 divisé en 3,000,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé et convenu de payer à la compagnie pour ses actions.earing date the 29th,day of November, 1950, were issued by the Lieutcnant-Governcr of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chaptrc 276, to the company \"Queen City Dress Company Limited\", ratifying its By-Law No.24: 1) increasing its capital stick from 849,900 to 8109,900 by the creation of 000 preferred shares of 8100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law; 2) adding to the letters patent certain provisions as mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 29th day of November, 1950.L.DÉSILETS, 29055-o Deputy Attorney General.Sport Togs Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of November, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Sport Togs Limited\", ratifying its By-law No.22 increasing its capital stock from $20,000 to $270,000 by the creation of 250,000 preferred shares of $1 each, subject to the rights, restriction and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 20th day of November, 1950.L.DÊSILETS, 29055-o Deputy Attorney General.The Bras D'Or Bay Navigation Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 7th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The Bras d'Or Bay Navigation Company Limited\", ratifying its Special By-Law \"C\": \"C\": 1.increasing its capital stock from $149,000 to $325,000 by the creation of $1760 additional preferred shares of 8100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law; 2.modifying the privileges and restrictions attaching to the preferred shares created by Special By-law \"B\" of the said Company, dated April 11th, 1929, and sanctioned by the Lieutenant-Governor on April 23rd, 1929.Dated at the office of the Attorney General, this 7th dav of December, 1950.L.DÊSILETS, 29055-o Deputy Attorney General.The MacGregor Paper & Bag Company, Incorporated Notice is hereby givtn that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary .letters patent, bearing date the 28th day of November, 1950 were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941; chapter 276: to the company \"The MacGregor Paper & Bag Company, Incorporated\" .ratifying its By-Law \"B\" increasing its capital stock by the creation of 1,926 preferred shares of $100 each to be subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 28th day of November, 1950.L.DÉSILETS, 29055-o Deputy Attorney General. 3276 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 The Main Fish Company Limited Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté ptr M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.It.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 30 novembre 1950, à la compagnie \"The Main Fish Company Limited\", ratifiant son \"Règlement No.41\" portant son capital-actions de $40,000 à $240,000 par la création de 2,000 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 30 novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29055 L.DÉSILETS.The.Royal Store, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Quebec*, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 novembre 1950, à la compagnie \"The Royal Store, Limited\", ratifiant son règlement No XXIII: a) créant et émettant 250 actions cemmuncs de $100 chacune du capital-actions autorisé sous forme de 250 actions privilégiées de $100 chacune; b) augmentant tel capital-actions de $49,000 à $74,000 par la création de 250 a< tions privilégiées additionnelles de $100 chacune; e) énumérant les droits, restrictions et privilèges attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le 23 novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29055-o L.DÉSILETS.The Main Fish Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of November.1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"The Main Fish Company Limited\", ratifying its By-Law No.41 increasing its capital stock from $40,000 to $240,000 by the creation of 2,000 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 30th day of November, 1950.L.DÉSILETS, 29055-o Deputy Attorney General.The Royal Store, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-third day of November 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The Royal Store, Limited\", ratifying its \"By-law No.XXIII\": a) creating and issuing 250 common shares of $100 each of Unauthorized capital as 250 preferred shares of $100 each; b) increasing said capital stock from $49,000 to $74,000 by the creation of 250 additional preferred shares of $100 each; c) anu-merating the rights, restrictions and privileges attaching to the preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1950.L.DÉSILETS, 29055 Deputy Attorney General.Actions en separation de biens Canada, Province de Québec, District de Roberval, Cour Supérieure, N° 13,206.Dame Lauréandc Boivin, demanderesse vs Paul Plante, défendeur.Dame Lauréandc Boivin, épouse de Paul Plante restaurateur de Desbiens, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.St- Joseph d'Alma, ce 18 déctmbre 1950.Vraie copie.Les Procureurs de la demanderesse, 2905l-o Gauthier & Falaudeau.Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 293759.Dame Helen Va-siliou, des Cité et district de Montréal, épouse commune en biens de John Rethmetakos, des Cité et district de Montréal, demanderesse, vs John Rethmetakos, des cité et district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée par la demanderesse contre le défendeur.Montréal, 22 décembre 1950.Les Procureurs de la demanderesse, 29057-o duranleau, dupré & duranleau.- Canada, Province de Québec, district de St-Hyacinthe, Cour Supérieure 6754.Dame Rita Fortin, épouse commune en biens de Michel Lebeau, de la Municipalité de St- Mathias, dis- Actions for separation as to property Canada, Province of Quebec, District of Roberval, Superior Court, No 13,206.Dame Lauréandc Boivin, plaintiff; vs Paul Plante, defendant.- Dame Lauréandc Boivin, wife of Paul Plante, restaurant keeper of Desbiens, has taken an action, against her husband, for separation as to property.St-Joseph d'Alma, December 18, 1950.True copy.Gauthier -& Falardeau, 29051 Attorneys for plaintiff.Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.293759.Dame Helen Va-silou, of the City and District of Montreal, wife common as to property of John Rethmetakos, of the City and District of Montreal, plaintiff, vs John Rethmetakos, of the City and District of Montreal, defendant.An action in separation as to property has been instituted by Plaintiff against Defendant.Montreal, December 22nd, 1950.DURANLEAU, DuPRK & DURANLEAU, 29057-o Attorneys for plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of St-Hyacinthe, Superior Court, 6754; Dame Rita Fortin, wife common as to property of Michel Lebeau, of the municipality of St-Mathias, dis- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3277 trict de St-Hyacinthe, vs Michel Lebeau, autrefois des mêmes lieux, maintenant de lieux in-eonnus.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le treizième jour de novembre 1950.Montréal, ce 27ème jour de décembre 1950.Les Procureurs de la.demanderessc, 29062-o DESPAROIS & MAILLET.trict of St.Hyacinthe; vs Michel Lebeau, heretofore of the same place, now of parts unknown.An action for separation as to property was instituted in this case on the thirteenth day of November 1950.Montreal, this 27th dav of December, 1950.DESPAROIS & MAILLET, 29062 Attorneys for the plaintiff.Arrêté en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1368 Québec, le 14 décembre 1950.Présent: Le Licutenant-Gouverneur-en-Conseil.Seciton \"A\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la eonstruction dans les comtés d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Charlevoix, Chicoutimi, Lac St-Jean-Roberval, Rouyn-Noranda et Saguenay.Attendu que conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), une requête a été présentée au Ministre du Travail par des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 1743 du 11 juillet 1941, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Charlevoix, Chicoutimi, Lac St-Jean, Roberval, Rouyn-Noranda et Saguenay, à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de.Québec, édition du 16 septembre 1950; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 1743, soit modifié comme suit: 1° Les taux de salaires minima établis à ''article V pour la zone I-A (comtés d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda), sont portés au même niveau que ceux de la zone I.Toutefois, les taux minima des plombiers, poseurs d'appareils' de chauffage et tôliers-ferblantiers sont les suivants, dans ladite zone I-A: L'heure Plombiers et poseurs d'appareils de chauffage .\u2022 \u2022 \u2022 $1.25 Tôliers (ferblantiers).1.25 Compagnions juniors (1 an).1.10 Apprentis: 1ère année.50% du salaire minimum 2ème année.60% 3ème année.70% 4ème année.80% 2° L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe \"b\" de l'article IV: Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1368 Quebec, December 14, 1950 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the construction industry and trades in the counties of Abitibi-East, Abitibi-West, Charlevoix, Chicoutimi, Lake St.John, Roberval, Rouyn-Noranda and Saguenay.Whereas, pursuant to the procedure provided for under section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163, and amendments), a request has been submitted to the Minister of Labour by contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 1743 of July 11.1941, relating to the construction industry and trades in the counties of Abitibi-East, Abitibi-West, Charlevoix, Chicoutimi, Lake St.John, Roberval, Rouyn-Noranda and Saguenay for the purpose of amending the said decree and its amendments; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of September 16, 1950; Whereas the objections thereto have been considered in pursuance of the provisions of the Act; It is ordaixed, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1743, be amended as follows: .1.The minimum rates of wages fixed in section V for 1-A (counties of Abitibi-East, Abitibi-West and Rouyn-Noranda) are increased to the level of those of zone I.However, the minimum rates of plumbers, steamfitters and tinsmiths are as follows in the said zone I-A: per hour Plumbers and steamfitters.$1.25 Tinsmiths.'.1.25 Junior journeymen (one year).1.10 Apprentices: 1st year.50% of the minimum rate 2nd year.60% 3rd year.70% 4th year.80% 2.The following paragraph is added to subsection \"b\" of section IV: 3278 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 décembre 1950, Tome 82, N° 62 \"Nonobstant les dispositions précédentes, dans la zone I-A, la durée maximum des heures régulières de travail est de 55 heures par semaine et aucun travail ne doit être exécuté le samedi après-midi, sauf par les gardiens de nuit.\" 3° Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1951.(Document \"A\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 29072-o Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers Paroisse de St-Honoré Comté de Chicoutimi TIRAGE D'OBLIGATIONS Les obligations suivantes, émises en vertu du règlement 38, ont été tirées au sort: Démmiination de $100.00: \u2014 C-63, 86, 91, 133, 157 et 175.Dénomination de $500.00 \u2014 D-45, 52, 61, 106, 153 et 188.Les dites obligations seront remboursables le 1er février 1951, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt.Le Secrétaire-trésorier, 29052-o FRANCIS DUFOUR.The Polish War Veterans Society of Marshal J.Pilstjdski Inc.Extrait des règlements de la société sus-nommée tel qu'adopté à une assemblée générale spéciale des membres d'icelle, tenue le 10 avril 1949, concernant une diminution dans le bureau de direction de la Société de dix-neuf à douze.\"Article IX, cemiposition de l'exécutif\" Paragraphe 2 \u2014 L'Exécutif sera formé comme suit: le Prosidént, le Premier Vice-président, le Second Vice-président, le Secrétaire, l'Assistant secrétaire, le Secrétaire financier, le trésorier, l'administrateur et le président des divers comtés\".Certifiée copie conforme.Le Secrétaire archiviste, 29053 MARCELI MAZURKIEWICZ.Collin's & Sons (Veneers) Limited Les Placages Collin Limitée Règlement N° 6 Réduisant le nombre des directeurs de cinq à trois.\"Le nombre des directeurs de la Compagnie est, par les présentes, réduit de cinq à trois, et le quorum des assemblées du bureau de direction sera de deux directeurs, et que les règlements généraux de la compagnie soient amendés en conséquence.\"Le présent règlement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les actionnaires et que les formalités de la loi quant à la publication dudit règlement auront été remplies.\" Montmagny, P.Q., 12 décembre 1950.Certifié vraie copie.Le Président, J.-E.COLLIN.Le Secrétaire, 29068-o MAURICE COLLIN.\"Notwithstanding the foregoing provisions, in zone I-A, the maximum duration of the regular hours of work shall be 55 hours per week and'no work is to be performed on Saturday afternoon, except by nieht watchmen.\" 3.The provisions of the present Order in Council shall come into force on January 1, 1951.(Document \"A\" annexed to the order) A.MORISSET, 29072-o Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices Parish of St.Honoré County of Chicoutimi DRAWING OF BONDS The following bonds, issued under By-law 38, have been drawn bv lots: Denomination of $100.00: \u2014 C-63, 86, 91, 133, 157 and 175.Denomination of $500.00: \u2014 D-45, 52, 61, 106, 153 and 188.The said bonds shall be redeemable on the 1st of February 1951, from which date they shall cease to bear interest.FRANCIS DUFOUR, 29052-o Secretary-Treasurer.The Polish War Veterans Society of Marshal J.Pilstjdski Inc.Extract of the by-laws of the above named Society, as adopted at a Special General Meeting of the members thereof held on April 10th, 1949, concerning a decrease in the directorate of the Society from nineteen to twelve: \"Article IX.Composition of the Executive Paragraph 2.The Executive shall consist of the following: President, First Vice-President, Second Vice-President, Secretary .Assistant Secretary, Financial Secretary, Treasurer, Administrator, and the Chairman of the various committees\" Certified a True Extract MARCELI MAZURKIEWICZ, 29053-o Recording-Secretary.Collin's & Sons (Veneers) Limited Les Placages Collin Limitée By-Law No.G Decreasing the number of directors from five to three.The number of directors of the Company is hereby decreased from five to three and two directors shall form a quorum at meetings of the Board of Directors, and that the general by-laws of the Company be amended accordingly.The present by-law shall come into force when ratified by the shareholders and when formalities concerning the publication of said by-law have been complied with.Montmagny, P.Q., Dedember 12, 1950.Certified true copy.J.E.COLLIN, President.MAURICE COLLIN, 29068 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3279 Monitor Publishing Company Limited Copie Certifiée du Règlement augmentant le nombre des Directeurs de \"Monitor Publishing Company Limited.\" de trois a quatre.Règlement N° 2S \"Qu'il soit et il est, par les présentes, adopté comme règlement N° 28 de \"Monitor Publishing Company Limited\" que le Règlement N° 8 de la Compagnie soit amendé comme suit: a) Biffer la première phrase de son premier alinéa et la remplacer par ce qui suit: \"Les affaires de la Compagnie seront dirigées par un bureau de quatre Directeurs, dont deux formeront un quorum pour la transaction des affaires\".b) Biffer la dernière phrase de son cinquième alinéa.Je, Lome Dewey MacBean, secrétaire-trésorier de \"Monitor Publishing Company Limited\" certifie par.les présentes que ce qui précède est une copie conforme du Règlement No.28 de \"Monitor Publishing Company Limited\" adopté par le Bureau de Direction à une réunion tenue le douzième jour de décembre 1950, et ratifié et approuvé par le vote unanime des actionnaires présents à une Assemblée générale pé-ciale dûment convoquée dans le but de considérer la proposition et tenue le douzième jour de décembre 1950.(Sceau) 29058-o (Signé) Lorne D.MacBean.Les Pétroles Inc.Règlement N° 72 Que le nombre dès directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à cinq de manière à ce que le bureau de direction de la compagnie soit, dorénavant composé de cinq directeurs.Tous les règlements, résolutions et procédures de la compagnie non conformes à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés afin de donner effet à ce règlement.Je, le soussigné, assistant-secrétaire de la compagnie \"Les Pétroles Inc.\", certifie, par la présente, que le précédent est une copie conforme d'un règlement décrété par le bureau de direction de la compagnie en date du 27 novembre 1950, et ratifié, confirmé et approuvé à l'unanimité à une assemblée générale spéciale de ladite compagnie tenue le 27 novembre 1950, et que ledit règlement est encore en vigueur et a plein effet.Daté à Québec, le 12 décembre 1950.L'Assistant-secrétaire, 29063 YVES PRATTE.Wrexham Investments Limited Sommaire du règlement pourvoyant à la distribution de l'actif.Le règlement douze de la compagnie décrété le 27 novembre 1950 stipule que, la compagnie ayant cessé d'exercer son commerce sauf dans le but de liquider ses affaires, le seul actif restant de la compagnie étant une solde d'argent, l'actif de la compagnie soit distribué au pro rata entre les actionnaires après expiration du délai légal.Le Secrétaire, 29064 G.R.BENNETT.Monitor Publishing Company Limited Certified copy of By-Law increasing the number of directors of \"Monitor Publishing Company Limited\" from three to four.By-Law No.28 \"Be it enacted and it is hereby enacted as By-law No.28 of \"Monitor Publishing Company Limited\" that By-law No.8 of the Company be amended as follows: a) By deleting the first sentence of the first paragraph thereof and replacing the same by the following: \"The affairs of the Company shall be managed by a board of four Directors, of whom two shall form a quorum for the transaction of business.\" b) By deleting the last sentence of the fifth paragraph thereof.\" I, Lorne Dewey MacBean, Secretary-Treasurer of \"Monitor Publishing Company Limited\", hereby certify the foregoing to be a true copy of By-law No.28 of \"Monitor Publishing Company Limited\" enacted by the Board of Directors at a meeting held o% the twelfth day of December 1950, ratified and confirmed by the unanimous vote of the shareholders present at a Special General Meeting of Shareholders duly called for the purpose of considering the matter and held on the twelfth dav of December 1950.(Seal) 29058-o Lorne D.MacBean.Les Pétroles Inc.By-Law No.72 \"The number of Directors of the Company be and the same is hereby increased from three to five so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of five Directors.All prior By-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this By-law.\" I, the undersigned.Assistant-Secretary of \"Les Pétroles Inc.\" do hereby certify that the foregoing is a true copy of a by-law enacted by the Board of Directors of the Company on the 27th day of November, 1950, and unanimously ratified, confirmed and approved at a Special General Meeting of said Company held on the 27th day of November, 1950, and that said By-law is still in full force and effect.Dated at Quebec, this 12th day of December, 1950.YVES PRATTE, 29063-o Assistant-Secretary.Wrexham Investments Limited Summary of By-Law providing for distribution of assets.' By-Law Twelve of the Company, enacted November 27th, 1950, provides that, as the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affaires, the sole remaining asset of the Company consisting of balance of cash, be distributed rateably among the shareholders after expiry of the legal delay.G.R.BENNETT, 29064-o Secretary. 3280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 La Manufacture de Meubles de Montmagny Limitée Montmagny Furniture Co.Limited Règlement N° U Réduisant le nombre des directeurs de cinq à trois \"Le nombre des directeurs de la compagnie est, par les présentes, réduit de cinq à trois, et les règlements généiaux de la compagnie sont amendés en conséquence.Le quorum pour les assemblées du bureau de direction sera de deux directeurs.\"Le piésent règlement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les actionnaires et que les formalités de la loi quant à la publication dudit règlement, auront été remplies.\" Montmagny, P.Q., 12 décembre 1950.Certifié vraie copie.Le Président, J.-E.COLLIN.Le Secrétaire, 29069-o GEO.-H.COLLIN.Les Produits Forestiers Collin (Ltée) Collin Lumber (Ltd) Règlement N° 30 Réduisant le nombre des directeurs dt cinq à trois \"Le nombre des directeurs de la compagnie est, par les présentes, réduit de cinq à trois, et le quorum des assemblées du bureau de direction sera de deux directeurs, et que les règlements généraux de la Compagnies soient amendés en conséquence.\"Le présent règlement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les actionnaires et que les formalités de la loi quant à la publication dudit règlement auront été remplies.Montmagny, P.Q., 1,2 décembre 1950.Certifié vraie copie.Le Président, J.-E.COLLIN.Le Secrétaire, 29070-o ROMÉO COLLIN.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM Veuillez prendre note du changement de nom de l'Association des Gardes-Malades diplômées de l'Hôpital Notre-Dame en celui de l'Association des Infirmières diplômées de l'Hôpital Notre-Dame conformément aux règlements de la Loi des assurances.Ce changement adopté par la dite société le 13 février 1948 a été adopté par le Surintendant des assurances et Inspecteur des sociétés de secours le 18 juillet 1950.La Secrétaire, 29073-o HÉLÈNE OLIVIER, I.L.La manufacture de Meubles de Montmagny, Limitée Montmagny Furniture Co.Limited By-Law No.1 + Decreasing the number of directors from five to three The number' of directors of the company is hereby decreased from five to three and the general by-laws of the Company are amended accordingly.Two directors shall form a quorum at meetings of the Board of Directors.The present by-law shall come into force when ratified by the shareholders and when law formalities concerning the publication of said by-law have been complied with.Montmagny, P.Q., December 12, 1950.Certified true copy.J.-E.COLLIN, President.GEO.H.COLLIN, 29069 Secretary.Les Produits Forestiers Collin (Ltée) Collin Lumber (Ltd) By-Law No SO Decreasing the number of directors from five to three The number of directors of the Company is hereby decreased from five to three, and two directors shall form a quorum at meetings of the the Board of Directors, and that the general bylaws of the Company be amended accordingly.The piesent by-law shall come into force when ratified by the shareholders and when law formalities concerning the publication of said by-law have been complied with.Montmagny, P.Q., December 12, 1950.Certified true copy.J.E.COLLIN, President.ROMÉO COLLIN, 29070 Secretary.NOTICE OF CHANGE OF NAME Please take notice of the change of name of \"Association des gardes-Malades diplômés de l'Hôpital Notre\" into that of \"Association des Infirmières diplômées de l'Hôpital Notre-Dame\" in conformity with the provisions of the Insurance Act.Said change of name adopted by the said Association on February 13, 1948, was adopted by the Superintendent of Insurance and the Inspector of the Mutual Benefit Associations on July 18, 1950.HÉLÈNE OLIVIER, R.N.29073 Secretary.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Le Syndicat Coopératif de Magog\", en date du 5 décembre 1950, dont le siège social est situé à Magog, comté de Stanstead, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 15 décembre 1950.* Donné au bureau du Secrétaire de la province Le Sous-secrétaire de la province, 29074-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Le Syndicat Coopératif de Magog\", under date the fifth day of December, 1950, whereof the head office is at Magog, county of Stanstead, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fifteenth day of December, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 29074 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December SOth, 1950, Vol.82, No.52 3281 Avis est donné par les présentes qu'un règlement spécial a été décrété par les directeurs de \"Trans-Canada Export Limited\" le 1er octobre 1950, en vertu de la loi des Compagnies de Québec, pourvoyant à la distribution de l'actif de la Compagnie parmi ses actionnaires.Montréal, le 1er décembre 1950.29075-o (Signé) ERNEST SALA.Perco Realty Inc.Sommaire du règlement N° 24 des règlements de la compagnie Il a été décrété: Que l'actif de la compagnie soit distribué au pro rata entre ses actionnaires.Passé en la cité de Montréal, le 15 décembre 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 29083 J.J.COOPER.Notice is hereby given that a special By-Law was enacted by the Directors of \"Trans-Canada Export Limited\" on October 1st, 1950, under the Provisions of the Quebec Companies' Act, providing for the distribution of the assets of the Company amongst its shareholders.Montreal, December 1st, 1950.(Signed) ERNEST SALA, 29075-o Secretary.Perco Realty Inc.Summary of By-Law No.2 of the Company's By-laws.It was enacted, That the assets of the company be distributed rateably among its Shareholders.Passed at the City of Montreal on the 15th day of December, 1950.(Seal) J.J.COOPER, 29083-o Secretary.Bills, Assemblée législative Avis de l'Assemblée Législative Concernant les bills privés qui seront présentés au cours de la présente session.Aux termes d'une motion adoptée par l'Assemblée législative le 16 novembre 1950, les délais fixés par le règlement concernant la déposition des bills privés chez le secrétaire des comités ont été prolongés- au 10 janvier 1951 et ceux de leur présentation au 14 février 1951; les délais fixés pour la présentation des pétitions introductives des bills privés ont été prolongés au 1er février 1951 et ceux de leur réception au 6 février 1951, et les délais prévus pour la réception des rapports des comités élus charges de l'examen des bills privés ont été prolongés au 28 février 1951.Québec, le 29 novembre 1950.Le Greffier, 28908-48-8-o ANTOINE LEMTEUX.Chartes \u2014 Abandon de Bills, Legislative Assembly Notice from the Legislative Assembly Relating to private bills to be introduced during the present session.Under the terms of a motion adopted by the Legislative Assembly on the 16th of November, 1950, the delays fixed by the rides and standing orders concerning the deposit of private bills with the Secretary of Committees have been extended to the 10th day of January, 1951, and those for their presentation to the 14th day of February, 1951; the delays fixed for the presentation of petitions for the introduction of private bills have been extended to the 1st of February, 1951, and those for their reception to he 6th of February, 1951, and the delays prescribed for receiving reports from select committees charged with the examining of private bills have been extended to the 28th of February, 1951.Quebec, November 29, 1950.ANTOINE LEMIEUX, 28908-48-8 Clerk.Charters \u2014 Surrender of AVIS Avis est donné que \"Hôpital Bellevue Inc.\", ayant son siège social à Québec, demandera au Procureur général la permission d'abandonner sa charte en conformité avec la Loi des compagnies de Québec.Québec, le 9 décembre 1950.Le Vice-président, 29054-o Dr ANTOINE COUTURE.AVIS LEGAL Avis est par les présentes donné que \"Fair-mount Investment Corporation\" s'adressera au Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce pour demander l'abandon de sa charte.Montréal, ce 28 décembre 1950.\u2022 Les Notaires, .29076-0 MORIN & MORIN.NOTICE Notice is hereby given that \"Hospital Bellevue Inc.\", with head office at Quebec, will apply to the Attorney General for leave to surrender its charter.Quebec, December 9, 1950.Dr ANTOINE COUTURE, 29054-o Vice-President.LEGAL NOTICE Notice is hereby given that \"Fairmount Investment Corporation\" shall apply to the Attorney General and to the Minister of Municipal Affairs, of Trade and Commerce for permission to surrender its charter.Montreal, December 28th, 1950.MORIN & MORIN, 29076 \" ¦ Notaries. 3282 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Wrexham Investments Limited Wrexham Investments Limited Avis de demande d'abandon de charte Notice of application for leave to surrender \u2014 charter Conformément aux dispositions de la Ixn des \u2014 compagnies de Québec, la compagnie \"Wrexham Under the provisions of the Quebec Companies' Investments Limited\" donne, par les présentes.Act, \"Wrexham Investments Limited\" hereby avis qu'elle s'adressera au Procureur général de la gives notice that it will make application to the province de Québec pour obtenir la pci mission Attorney General of the Province of Quebec for d'abandonner sa charte et la fixation d'une date leave to surrender its charter and to fix a date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute, upon and from which the company shall be dissolved.Montreal, 21 décembre 1950.Montreal, December 21st, 1950.Le Secrétaire, G.It.BENNETT, 290G5 G.It.BENNETT.29065-o Secretary.Compagnie autorisée à faire Companie Licensed to do des affaires Business Avis est, par les présentes, donné que la com- Notice is hereby given that the company pagnie \"Stuyvesant Industries Inc.\", a été auto- \"Stuyvesant Industries Inc.\", has been authorized rise à exercer son commerce dans la piovince de to carry on business in the Province of Quebec.Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par The powers conferred upon the said company sa charte seront limités à ceux accordés aux cor- by its charter shall be limited to those granted porations de même nature créées en vertu des to corporations of like nature created in virtue of Lois de la province de Québec, et sujets aux the laws of the Province of Quebec, and subject mêmes formalités telles que prescrites par les to the same formalities as are prescribed by the lois existantes dans cette Province.existing laws of this Province.L'agent principal de ladite compagnie dans cet- The chief agent of the said company in this te Province, aux fins de recevoir les assignations Province for the purpose of receiving service in dans toute poursuite ou procédure intentée contre any suit or proceeding taken against it is Wil- elle, est M.William Fraser Macklaicr, avocat et liam Fraser Macklaier, Advocate and King's conseil en loi du Roi, de la cité de Westmount.Counsel, of the City of Westmount.Le bureau principal de la corporation dans la The principal office of the Company in the Province est N° 1300, Edifice Aldred, 507 Place Province of Quebec is established at No.1300 d'Armes, en la cité de Montréal, district judici- Aldred Building, 507 Place d'Armes,, in the city aire de Montréal.and judicial district of Montreal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, Given at the office of the Provincial Secretary, le vingt-et-un décembre, 1950.this 21st dav of December, 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 29049 \u2022 JEAN BRUCHÉSI.29049-o Under Secretary of the Province.Demandes à la Législature AVIS PUBLIC La Cité de Sillery donne avis qu'elle s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, aux fins d'obtenir l'adoption d'une loi amendant sa charte et lui accordant les pouvoirs additionnels suivants: Le droit d'emprunter annuellement sans referendum mais avec l'approbation de la commission municipale de Québec, une somme de cent mille piastres pour travaux urgents d'aqueduc et d'égoût; la distribution de la taxe de vente édictée par la loi IV, George VI, chapitre 74, section 3, telle que modifiée par la loi V George VI, chapitre 72, section 15, au prorata de la population des municipalités concernées, basée sur un recensement annuel au lieu de décennal; approbation des règlements concernant les règlements de construction et de zonage; l'apposition et l'exposition d'affiches, de photographies et d'autres moyens publicitaires quelconques; la distribution par tous moyens de pamphlets et autres imprimés ou objets quelconques.La vente des immeubles pour taxes.Québec, 21 décembre 1950.Le Procureur de*ïa requérante, 29067-52-4-o PHILIPPE LANCTOT.Applications to Legislature PUBLIC NOTICE The City of Sillery gives notice that it will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act amending its charter and granting to it the following additional powers: The right to borrow annually without a referendum but with the approval of the Quebec Municipal Commission, a sum of one hundred -thousand dollars, for urgent water and drain works; the distribution of the sales tax enacted by the Act IV George VI, chapter 74, section 3, as amended by the Act V George VI, chapter 72, section 15, prorata to the population of the municipalities concerned, based on an annual instead of a decennial census; the approval of the bylaws respecting the building and zoning regulations; the posting and exhibiting of advertisements, photographs, and any other means of publicity Whatsoever; the distribution, by any means, of pamphlets and other printed matter or any objects whatsoever.The sale of immovables for taxes.Quebec, December 21, 1950.PHILIPPE LANCTOT, 29067-52-4 Attorney for the plaintiff. QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3283 Avis que \"Les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de Mont-Laurier\", constituées en corpora-tionjpar la loi 25-26 George V, chapitre 153, vu leur passage canonique à l'ordre de Saint-Benoît, s'adresseront à la Législature de la Province, à sa présente session, pour obtenir une loi modifiant ladite loi et particulièrement changeant leur nom en celui de \"Les Moniales Bénédictines du Précieux-Sang de Mont-Laurier.\" Donné à Mont-Laurier, le 21 décembre 1950.L'agent des requérantes, 29066-52-4-o ROMÉO OUELLETTE, notaire.Avis de presentation d'un bill privé Le soussigné donne avis qu'un bill privé sera présenté au cours de la présente session de la législature de Québec par \"Perron Gold Mines Limited\", ayant pour objet de prolonger du 21 décembre 1950 au 21 décembre 1955 l'application du chapitre 246 des Statuts Refondus de Québec (1941) et ses amendements au village minier de Pascalis dans le comté de Abitibi Est.L'Agent de la pétitionnaire, 29078r52-4-o LUCIEN TOURIGNY, C.R.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que les Commissaires d'école pour la municipalité de Plessisville, dans le comté de Mégantic, s'adresseront à la Législature de Québec, à sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi leur accordant le pouvoir d'imposer et de prélever une taxe d'éducation de 1% dans les limites de Plessisville.Le Procureurs des pétitionnaires, ANTONIO BEAUDOIN, C.R.29084-52-4-o AVIS PUBLIC La Cité de Drummondville donne avis qu'elle s'adressera à la Législature Provinciale, à sa présente session, pour obtenir des modifications à sa charte et a certaines dispositions de la loi des cités et villes, sur les matières suivantes.1° Le pouvoir d'acquérir, construire, un ou des immeubles devant servir en totalité ou en partie à des fins municipales ou industrielles dont le coût ne devra pas dépasser trois cent cinquante mille dollars.2° Le pouvoir de réglementer et limiter l'émission des permis au propriétaires et chauffeurs de taxis.3° Le pouvoir d'emprunter une somme n'excédant pas cinquante mille dollars pour travaux permanents et urgents.4° Le pouvoir d'ordonner par résolution que le rôle d'évaluation soit composé de fiches et de feuilles volantes.5° Le pouvoir de réglementer la subdivision d'un terrain en lots à bâtir, et l'emplacement des rues à ouvrir sur le dit terrain.6° Le pouvoir d'augmenter la capacité d'emprunt de la cité.7° Le pouvoir d'imposer certaines taxes d'affaires.8° Tout autre pouvoir nécessaire à la bonne administration de la Cité.Le Procureur de la Cité de Drummondville, 28985-50-4-o ROGER SÉGUIN.Notice that \"Les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de Mont-Laurier\", incorporated under the Act 25-26 George V, chapter 153, according to their canonical passage to the Order of Saint Benedict, will address to the Legislature of the Province, at its pressent session, as to obtain an act amending the said act and namely changing their name to that of \"Les Moniales Bénédictines du Précieux-Sang de Mont-Laurier\".Given at Mont-Laurier, December 21st, 1950.ROMÉO OUELLETTE, Notary, 29066-52-4-o Agent for the Applicants.Notice of Presentation of a Private Bill The undersigned gives notice that a private bill shall be presented in the course of the actual session of the Quebec Legislature by \"Perron Geld Mines Limited\", the object of which is to extend from December 21st, 1950 to December 21st.1955 the application of Chapter 246 (Revised Statutes Quebec 1941 and its amendments) to the mining village of Pascalis, in the countv of Abitibi East.LUCIEN TOURIGNY, K.C., 29078-52-4-o Agent for Petitioner.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the school commissioners for the Municipality of Plessisville, in the county of Megantic, will apply to the legislature of Quebec, at its present session for the passing of an Act granting them the power to levy and impose an education tax of 1% within the limits of Plessisville.ANTONIO BEAUDOIN, K.C., Attornty for the petitioners.29084-52-4 PUBLIC NOTICE \u2014 \u2022 The City of Drummondville gives notice that it will present a bill at the present session of the Provincial Legislature to obtain amendments to its charter and to the act respecting Cities and Towns on the following matters.1.The power to acquire or erect one or more immoveables to be used, wholly or in part, for municipal or industrial purposes, the total cost of which shall not exceed three hundred and fifty thousand dollars.2.The power to regulate and limit the issue of permits to owners and drivers of taxis.3.The power to borrow annually a sum not exceeding fifty thousand dollars for urgent and permanent works.4.The power to order by resolution that the valuation roll be composed of card-indexes or loose leaves.5.The power to regulate the subdivision of any land into building lots and the laying out of the streets upon such land.6.The power to increase the borrowing capacity of the city.7.The power to impose and levy duties on certain trades.8.Any other power necessary to the good administration of the city.ROGER SÉGUIN, Attorney for the City 28985-50-4-o of Drummondville. 3284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 décembre 1950, Tome 82, N° 52 AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que le Bureau central des Ecoles Protestantes de Montréal s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session pour la passation d'une Loi amendant la Loi 15 George V, chapitre 45, et les diverses lois amendant ladite Loi, dans le but de: o) Changer le nom du Bureau Central; b) Changer la date des nominations; c) Augmenter la représentation dans le bureau ; d) Clarifier ses pouvoirs; e) Autorisant le Bureau de faire des contrats pour l'assurance collective sur la vie (group life insurance); /) Et pour autres fins.Montréal, le 15 novembre 1950.Ié Procureur du Bureau central des Écoles protestantes de Montréal, 28986-50-4 ALFRED M.WEST.AVIS Avis est par les présentes donné que Dame Jeannine Legault, épouse de M.Raymond Girard, de la cité de Verdun, s'adressera à la Législature Provinciale à sa présente session pour demander de corriger le testament du Feu Henri Legault, daté le 4 septembre 1941.Montréal, le 30 novembre 1950.Le Procureur de la requérante, 28938-49-4-0 ROGER DESMARAIS, C.R.AVIS PUBLIC Les légataires de feu Hugh Quinlan ci-devant entrepreneur de la cité de Westmount, donnent avis qu'il s'adresseront à la législature de la province de Québec à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi autorisant et ordonnant la distribution partielle du capital de la succession dudit feu Hugh Quinlan.Montréal, le 15 décembre 1950.Le Procureur des Pétitionnaires, 29032-51-4-o EDOUARD MASSON, C.R.Avis public est par les présentes donné que la Cité de Grand'Mère' et les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Mère dans le comté de Champlain s'adresseront conjointement à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins de ratifier à la fois le règlement numéro 461 de la dite Cité et une résolution desdits Commissaires d'écoles adoptée le 4 décembre 1950; ledit règlement et ladite résolution fixant tous deux, pour fins municipales et pour fins scolaires respectivement, le mode d'évaluation durant une période future de dix années des biens industriels imposables de The Shawinigan Water and-Power Company et de Consolidated Paper Corporation limited dans la municipalité de Grand'Mère; et ledit règlement numéro 461 pourvoyant additionnellement à la tenue de la comptabilité de la Cité, à l'adoption de ses budgets, au maintien de son administration par gérant et au mode d'aviser les compagnies lorsque dès règlements sont soumis aux électeurs propriétaires.Grand'Mère, le 5 décembre 1950.Le Procureur de la Cité de Grand'Mère et des Commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Mère dans le comté de Champlain, 28948-49-4-0 MARCEL CRÊTE.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that The Montreal Protestant Central School Board will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act, amending the Act 15 George V, chapter 45, and to various Acts amending same, for the purpose of : o) Changing the name of the Central Board: b) Changing the date of appointments: c) Increasing the representation on the board: d) Clarification of its powers : e) Empowering the board to enter into contracts for group life insurance./) And for other matters.Montreal, November 15, 1950.ALFRED M.WEST, Attorney for The Montreal Protestant 28980-50-4-o , Central School Board.NOTICE Notice is hereby given by Mrs.Jeannine legault, wife of Mr.Raymond Girard, of the city of Verdun, that she shall apply to the Quebec Legislature, durant its present Session to ask to amend the will of the late Henri legault, dated September 4th 1941.Montreal, November 30th 1950.ROGER DESMARAIS, K.C.28938-49-4-0 Attorney for Petitioner.PUBLIC NOTICE The legatees of the late Hugh Quinlan, heretofore contractor of the City of Westmount, give notice that they will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act authorizing and ordering the partial distribution of the capital of the Estate of the said late Hugh Quinlan.Montreal, December 15, 1950.EDOUARD MASSON, K.C, 29032-5l-4-o Attorney for Petitioners.Public notice is hereby given that the City of Grand'Mère and the School Commissioners for the Municipality of Grand'Mère in the County of Champlain will jointly apply to the Legisla ture of the Province of Quebec, at its present session for the passing of an Act to ratify a bylaw of the said City bearing number 461 as well as a resolution of the said School Commissioners adopted on December 4th 1950; both said by-law and said resolution fixing, for ten years, for municipal and for school .purpoies respectively the mode of valuation of the industrial taxable property of The Shawinigan Water and Power Company and of Consolidated Paper Corporation Limited within the municipality of Grand'Mère; and said by-law number 461 relating additionally to the accountancy of the City, to the adoption of its budgets, to the maintenance of its manager administration system and to the way\" of advising the companies when by-laws are submitted to the electors who are proprietors.Grand'Mère, December 5, 1950.MARCEL CRÊTE, Attorney for the City of Grand'Mère and the School Commissioners for the Municipality of Grand.-28948-49-4-o Mere in the County of Champlain. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December SOth, 1950, Vol.82, No.52 3285 AVIS Avis est par les présentes donné que Dame Aima Girard, épouse contractuellement séparée de biens de J.Alfred Brousseau, de la Ville de Mégantic, district de St.François, sollicitera auprès de la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi l'autorisant à vendre ou à hypothéquer en complète propriété, comme seule propriétaire le lot de terre numéro 2070, sur les plan et livre de renvoi officiels de la Ville de Mégantic, avec bâtisses, légué avec restrictions par feu Eugène Girard, peintre, de la Ville de Mégantic.Sherbrooke, le 30 novembre 1950.Le Procureur de la requérante, 28915-49-4-0 ARMAND NADEAU, C.R.Avis est donné que L'Institut des Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chiétienne, constitué en corporation par la loi 6 Georges V, chapitre 103, s'adressera à la Législature de Québec, à sa session actuelle, pour obtenir des amendements à ladite loi aux fins suivantes: mieux définir ses buts et certains pouvoirs qu'il a actuellement; acquérir toutes propriétés mobilières et immobilières, pourvu (pic le revenu annuel des immeubles appartenant à la corporation et possédés par elle pour fins de revenus n'excède pas la somme de trois cent mille dollars: engager ses biens meubles et immeubles de toutes manières, pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations, contractés spécialement par émission d'obligations ou d'autres titres ou valeurs; défi nir que les pouvoirs de la corporation seront exercés par son.conseil d'administration, composé ainsi qu'il sera statué; abroger l'article 7 de ladite loi et édicter des dispositions relatives à la dissolution de ladite corporation, à la représentation de ses membres par ladite corporation, aux officiers dont la signature liera celle-ci, à la modification du nom corporatif et du siège social de celle-ci, de même qu'à certains établissements et certaines constructions à ériger.Québec, 5 décembre 1950.Les Frocureurs de L'Institut des Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne, 28949-49-4-0 GTJÊRARD et PELLAND.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville de Sainte-Rose s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la loi 8 George V, chapitre 98, sur les matières suivantes: imposer une taxe sur tous les propriétaires ou occupants d'immeubles de la municipalité pour la construction d'aqueduc public, citernes ou réservoirs; exiger des propriétaires d'immeubles une taxe pour le service de l'aqueduc lorsque la durée du bail est moindre qu'un an; permettre la modification des quartiers de la ville et faire représenter chacun des quartiers par deux éche-vins dont l'un sera élu par les propriétaires électeurs seulement et l'autre par tous les électeurs; exiger que chaque construction projetée soit érigé sur un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision; taxation des terres en culture; procédures pour exécution de travaux permanents; destitution du vérificateur, du directeur de la police et du secrétaire NOTICE Notice is hereby given that Mrs Anna Girard, wife legally separated as to property of J.Alfred Brousseau, of the Town of Megantic, district of St.Francis, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act authorizing her to sell or mortgage in complete ownership, as sole owner, the lot number 2070, upon the official cadastral plan and in the book of reference of the Town of Megantic, with buildings, donated with restrictions by tin late Eugene Girard, painter, of the Town of Mégantic.Sherbrooke, November 30th 1950.ARMAND NADEAU, K.C.28915-49-4-o Attorney for the Petitioner.Notice is given that The Institute of the Sisters of the Childhood of Jesus and Mary, or Sisters of St.Chrétienne, a body incorporated under the Act 6 George V, chapter 103, will apply to the Legislature of Quebec, at its present session, in order to obtain amendments to said Act, as follows: define more clcrly its aims and certain powers that he now possesses; acquire all moveable and immoveable property, provided that the annual revenue of the immoveables belonging to the corporation and owned by it for purposes of revenue docs not exceed three hundred thousand dollars; encumber its immoveable of immoveable property in any way wer, to secure the payment of its loans of the carrying of its obligations, specially by issuing bonds or other title-deeds or securities; declare that the powers of said corporation shall be exercised by its council of administration, composed in the manner which shall be defined; repeal section seven of said Act and enact dispositions relating to the dissolution of said corporation, to the representation by said corporation of its members, to the officers whose signatures shall bind said corporation, to the altering of its corporate name of the place of its corporate seat, and to certain establishments and buildings to be erected.Quebec, December 5th, 1950.GUÊRARD and PELI AND, Attorneys for The Institute of the Sisters of the Childhood of Jesus and Mary, or Sisters of St.Chrétienne.28949-49-4-0 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of Sainte-Rose will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session for the adoption of a law amending its charter the Act 8 George V, chapter 98, for the following purposes: to impose a tax on all the owners or occupants of immoveables of the municipality for the construction of water-works, public wells, cisterns or reservoirs; to exact from the property-owners a compensation for the water service when the term of the lease is under one year; to allow the modification of the wards of the town and to have two aldermen representing each ward, one to be elected by the property-owners only and the other by all the electors; to exact that each proposed building be erected on a distinct lot on the official plan of the cadastre or on a subdivision plan; taxation of farm lands; proceedings for the execution of permanent works; destitution of the auditor, of the director of the police department and of the secretary-treasurer 3286 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 trésorier, conformément au chapitre 235 des Statuts Refondus de Québec 1941; procédures concernant contravention aux règlements municipaux relatifs à la circulation et à la sécurité publique; création d'un fonds de roulement; encouragement des arts, sciences, établissement de centres de loisirs et organisation des jeux et des sports et pour autres fins.Montréal, ce 5 décembre 1950.Les Procureurs de la Ville de Sainte-Rose, 28951-49-4-o Lacroix, Lafontaine & Viau.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville LaSalle s'adressera à la législature de la province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la Loi 2 Georges V, chapitre 73 et amendements, sur les matières suivantes: organiser ou subventionner un service de transport en commun dans ses rues et valider la subvention donnée à la Compagnie des tramways de Montréal durant l'année 1950; pouvoir d'acquérir ou construire tout égout public et imposer taxe pour en payer le coût; exiger compensation pour service d'égouts et pour autres fins.Montreal, ce 30 novembre 1950.Les Procureurs de Ville LaSalle, 28950-49-4-o Lacroix, Lafontaine & Viau.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que le Bureau des Commissaires des Écoles protestantes de la cité de Montréal, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session pour la passation (l'une Loi amendant la Loi 32 Victoria, chapitre 16, et les diverses lois amendant ladite Loi, dans le but: D'augmenter le nombre des membres du Bureau des Commissaires des Écoles protestantes de la cité de Montréal.Montréal, le 15 novembre 1950.Le Procureur du Bureau des Commissaires des Écoles protestantes de la cité de Montréal, 28987-50-4 ALFRED M.WEST.AVIS Avis est par les présentes donné que la Ville St-Laurent s'adressera à la Législature de Québec lors de sa présente session pour obtenir certains amendements à sa charte et aux différents statuts qui la modifient sur les matières suivantes: 1° Amendement aux articles 5 et 7 du Ch.94 de la Loi 8, Edouard VII, concernant la division de la Ville en quartiers et la composition du Conseil.2° Échange de certaines parties du territoire avec la Cité de Montréal.3° Amendement à l'article 10 du Ch.91 de la loi 11, Geo.VI, concernant les règlements de zonage et de construction.4° Amendements à l'article 4 du Ch.89 de la Loi 13, Geo.VI, ayant pour effet de changer les mots \"La Commission Municipale de Québec\" par \"Le Ministre des Affaires Municipales\".5° Autoriser le Conseil à payer à môme les fonds généraux une pension à certains employés et pour toutes autres fins.Les Procureurs de la requérante, Patenaude, Patenaude, 28988-50-4-o Trahan & Hodge.according to Chapter 235 of the Revised Statutes of Quebec, 1941 ; proceedings concerning offences to the traffic and public securities by-laws of the town; encouragement to the arts, sciences establishment of recreation centers and organisation of games and sports and for all other purposes.Montreal, December 5th, 1950.Lacroix, Lafontaine & Viau, Attorneys for the Town of Sainte-28951-49-4-0 Rose.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of LaSalle will apply to the législature of the province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act amending its charter, the Acte 2 George V, chapter 73 and amendments, for the following purposes: to organize or to subsidize a public serviee transportation on its streets and to validate the subsidy given to the Montreal Tramways Company for the year 1950; to obtain the power to acquire or to build any public sewers and to impose a tax to pay the costs of same: to exact compensation for the sewer service and for other purposes.Montreal, November 30th, 1950.Lacroix, Lafontaine & Viau, 28950-49-4-o Attorneys for the Town of LaSalle PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the Protestant Board of School Commissioners of the City of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act, amending the Act 32 Victoria, chapter 16, and the various Acts amending same, for the purpose of: Increasing the membership of the Protestant Board of School Commissioners of the City of Montreal.Montreal, November 15, 1950.ALFRED M.WEST, Attorney for the Protestant Board of School Commissions 28987-50-4-o of the City of Montreal.NOTICE Notice is hereby given that the Town of St.Laurent will apply at the Legislature of Quebec at its present session to obtain certain amendments to its charter and to the statutes amending it on the following matters: 1.To amend articles 5 and 7 of Ch.94 of the Law 8 Ed.VII concerning the division of the Town in wards and the composition of the Council.2.To exchange certain parts of its territory with the City of Montreal.3.To amend article 10 of Ch.91 of the Law II Geo.VI concerning the zoning and construction by-laws.4.To amend article 4 of Ch.89 of the Law 13 Geo.VI to that effect of changing the words \"the Municipal Commission of Quebec\" by \"the Minister of Municipal Affairs\".5.To authorise the payment with the general funds of a pension to certain employees and for all other purposes.Patenaude, Patenaude, Trahan & Hodge, 28988-50-4-o Attorneys for the Petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 80th, 1950, Vol.82, No.52 3287 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné par Dame Angelina Bacon, veuve de Real Lamontagne, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à sa fille Lise, Roger Lamontagne, commis-marchand, René et Raoul Lamontagne, marchants, tous de la Cité d'Outremont, district de Montréal, qu'ils demanderont à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, d'adopter une loi- pour interpréter et compléter lè testament de feu Real Lamontagne, en son vivant marchand, de la Cité d'Outremont.Montréal, le 1er décembre 1950.L'Avocat des requérants, 28916-4Ô-4-0 ÉMILIEN BRAIS.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville de Black Lake, dans le comté de Mégantic, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à la présente session, pour obtenir l'adoption d'une Loi pour les fins suivantes: Pour obtenir le droit d'imposer une taxe de vente n'excédant pas deux pour cent (2%) dans ses limites et les limites de la Cité de Thetford Mines, au pro rata de leur population respective; pour refuser des permis de construction sur les lots non cadastrés; pour rendre obligatoire par règlement la taxe de vidanges, qu'il en soit déposé ou non; pour régler sommairement par billets d'assignation obligeant à payer la somme de deux dollars ($2.) à toute personne violant les règlements de la circulation; pour obliger les propriétaires de taxis à prendre un permis annuel au montant de dix dollars ($10.) et un permis annuel de cinq dollars ($5.) pour les conducteurs; pour déclarer que les taxes spéciales imposées par les articles 439, 441 et 442 de la Loi des Cités et Villes soient perçues comme les taxes générales et que les arrérages constituent, comme les taxes foncières, une charge hypothécaire sur les immeubles affectés; pour décréter que les longues herbes nu toutes formes de détritus ou amoncellements sur les lots vacants constituent des nuisances, et prendre les moyens pour les faire cesser; pour décréter que les locataires ou occupants ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs à moins d'avoir payé leurs taxes; pour permettre que les avis publics ne soient donnés qu'en français; pour que sa charte lui permette de continuer à imposer la taxe spéciale sur les compagnies minières, en remplaçant dans la Loi 24 George V, chapitre 103, les mots \u2022 trente-cinq (35) par cinquante-cinq\" (55); et pour autres fins.Black Lake, ce 18 décembre 1950.Le Procureur de la Ville de Black Lake, 29042-51-4-o LUCIEN DROLET, C.R.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given by Dame Angelina Bacon, widow of Real Lamontagne, both personally and as tutrix to her daughter Lise, Roger Lamontagne, salesman, René and Raoul Lamontagne, merchants, all of the city of Outre-mont, district of Montreal, that they will apply to the Legislature of the Province of Qucl)ec, at its session, for the passing of an Act to interpret and complete the Will of the late Real Lamontagne, in his lifetime a merchant, of the City of Outremont.Montreal, December 1, 1950.ÉMILIEN BRAIS, 28916-49-4 Attorney for petitioners.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of Black Lake, in the county of Mégantic, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act for the following purposes: To obtain the right to impose a Sales Tax not exceeding two per cent (2%) within its limites and the limits of the City of Thetford Mines, in proportion to their respective population; to refuse building permits on unsubdivided lots; to render the garbage tax obligatory, by by-law, whether deposited or not; to settle summarily by a notice of summons obliging any person, violating traffic regulations, to pay the sum of two dollars ($2) ; to oblige taxi owners to procure an annual license for the amount of ten dollars ($10) and an annual license of five dollars ($5) for the drivers; to declare that the special taxes imposed by sections 439, 441 and 442 of the Cities and Towns Act be collected as general taxes and that arrears constitute, in the same manner as ground taxes, a hypothecary charge on the immovables affected; to enact that weeds or any form of rubbish or debris on vacant lots, constitute a nuisance, and to take measures to eliminate same; to enact that lessees or occupants shall not be entered on the list of electors unless they have paid their taxes; to allow public notices to be given in French only; So that its charter may continue to impose a special tax on mining companies, by replacing in the Act 24 George V, chapter 103, the words thirty-five (35) by \"fifty-five\" (55); and for other purposes.Black Lake, this 18th day of December, 1950.LUCIEN DROLET, K.C., .29042-51-4 Attorney for the Town of Black Lake.Département des Affaires municipales Le soussigné donne avis que tel que demandé par une résolution du 4 décembre 1950 du conseil de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes de Ham, Comté de Wolfe, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a décrété, en date du 21 décembre 1950, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Quebec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Department of Municipal Affairs The undersigned notice that as requestde by a resolution of the 4th of December, 1950, from the Council of the Parish of Notre-Dame de Lourdes de Ham, county of Wolfe, and pursuant to the provisions of Article 130 of the Municipal Code, he has enacted, under date the 21st of December, .1950, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required Quebec Official Gazette, be made in the future, in the French, in the French language only. 3288 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 62 Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 21 décembre 1950.Le Ministre des Affaires municipales, 29050-o BONA DUSSAULT.The present notice is published in conformity with article 131 of the Municipal Code.(10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, December 21, 1950.BONA DUSSAULT, 2050 Minister of Municipal Affairs.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec Ordonnance N° 7-50A Extrait des procès verbaux des séances de la Commission de.l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi, 20 décembre 1950 tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal à 10.00 heures a.m.Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert.Adrien Angers, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, C.-A.Gamache, Cit., A viseur légal.Après avoir considéré les conditions (\\e l'Industrie laitière dans la région de Rivière-du-Loup, La Commission décrète ce qui suit: 1° L'ordonnance N° 7-50, publiée dans la Gazette officielle de Québec du 28 octobre 1950 est amendé et l'article 2° est remplacé par le suivant : \"2° La région de Rivière-du-Loup comprend la cité de Rivière-du-Loup et le village de l'isle Verte.\" La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Le secrétaire de ladite Commission est charge de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer E.Milot, président, Joseph Hébert, Commissaire, Adrien Angers, Commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, Secrétaire.29086-o Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.7-50A Excerpts from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Wednesday December, 20th 1950, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Omer E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, C.A.Gamache, K.C., légal Adviser.Considering the conditions of the dairy industry within the region of Rivière du Loup.It is exacted as follows : 1.Order No.7-50, published in the Quebec Official Gazette of October 28th, 1950 is amended and article 2 is replaced by the following: \"2.The region of Rivière-du-Loup includes the City of ltivière-du -Loup and the village of ITsle Verte\".The present Order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.% The Secretary of said Commission is charged* with the publication of the present Order in the Quebec Official Gazette.Signed: Omf.r E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.29086-o Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de plombiers et de poseurs d'appareils de chauffage dans les comtés de Maskinongc, St-Maurice, La-violette, Champlain et Trois-Rivières lui ont présenté une requête à l'effet de modifier le décret numéro 338, du 11 mars 1948.On demande: Que l'article III soit remplacé par le suivant: \"III.Taux de salaire minimum: a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés pour chacun des métiers ci-après: Plombiers, poseur d'appareils de chauffage et accessoires, d'appareils de réfrigération et gi- Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antojiio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act(R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the plumbing and steamfitting trades in the counties of Maskinongé, St-Maurice Laviolctte, Champlain and Three Rivers have submitted to him a request to amend the decree number 338 of March 11, 1948.It is requested: That section III be replaced by the following: \"III.Minimum Rates oj'Wages: a) The following minimum rates of wages shall be paid for each of the trades mentioned hereinafter: Plumbers, steamfitters and accessories, refrigeration mechanics, sprinkler fitters, exygen and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, I960.Vol.82, No.62 3289 clcurs, soudeur à l'oxygène, et à l'électricité, ferblantier-couvreur et mécanicien en isolement d'amiante: Salaires horaires Entrepreneur (services personnels).$1.80 Compagnon senior.1.20 Compagnon junior.1.00 Un employeur ne peut rémunérer au taux prévu pour un compagnon junior plus d'un (1) salarié par cinq (5) salariés rémunérés aux taux de compagnon senior ou par fraction de ce nombre.Apprentis: Première année.$0.40 Deuxième année.0.55 Troisième année.0.65 Quatrième année.0.75 Journalier.,.0.80 Aucun employeur ne peut employer plus d'un apprenti pour chaque compagnon à son emploi.b) D'accord avec l'article 13 de la loi, rien n'empêche un ou plusieurs employeurs, ou une association d'employeurs, d'établir ou de maintenir, par accords individuels ou collectifs, des conditions de salaires comportant des compensations ou avantages plus étendus que ceux fixés par le présent décret, tels accords gardant leur plein effet, nonobstant les dispositions du présent article.c) Les salariés doivent être payés chaque semaine.\" Les parties contractantes ont convenu que les dispositions du présent décret d'amendement aient leur effet à compter du Ici janvier 1951.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GERARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 30 décembre 1950.29077-o electricity welders, tinsmith-roofers and asbestos insulation mechanic: Hourly rates Contractor (personal services).SI.80 Senior-journeyman.1.20 Junior-journeyman.1.00 An employer shall not pay at the rate fixed for a junior journeyman more than one (1) employee to each five (5) others paid the rate of senior journeyman, or fraction thereof.Apprentices: First year.SO.40 Second year.0.55 Third year.0.65 Fourth year.0.75 Common workers.0.80 No employer may employ more than one (1) apprentice to each journeyman in his employ.b) Pursuant to section 13 of the Act, any employer or association of employers may establish or maintain, through private or collective agreements, working conditions with more extended compensations or benefits than those provided for in the present decree, such agreements remaining in full effect notwithstanding the provisions of the present section.c) The employees shall be paid every week.\" The contracting parties have agreed to be bound by the provisions of the present amending decree from January 1, 1951.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GERARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 30, 1950.29077-o Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DU BAS SAINT-LAURENT \u2014 BAR OF THE LOWER SAINT LAWRENCE Candidats poor l'admission a la pratique du droit CaNIDTES for THE admission to THE PRACICE of law Examens de janvier 1951 \u2014 Examinations of January, 1951 \\ Noms Names\tPrénoms Surnames\t\tAge\tRésidence Residence Bérubé.\t\t\t25\tAmqui.Rimouski.\tJ.-Edouard\t\t25\t \t\t\t\t Rimouski, le 21 décembre 1950 \u2014 Rimouski, December 21, 1950.Le Secrétaire du Barreau du Bas Saint-Laurent, MAURICE TESSIER, 29082-52-2-o Secretary of the Bar of the Lower Saint Lawrence 3290 G A ZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1960, Tome 82, N° 62 BARREAU DE MONTRÉAL \u2014BAR OF MONTREAL Candidats pour l'admission a la pratique du droit Candidates for the admission to the practiob of law Examens de janvier 1951 \u2014 Examinations of January, 1951 n0ii18 Names\tPrénoms Surnames\tAge\tRésidence Residence \t\t26 33\tMontréal.Montréal.\t\t\t \t\t\t Montréal, le 27 décembre 1950 \u2014 Montreal, December 27, 1950.29082-52-2-o Le Secrétaire, W.E.BRONSTETTER.Secretary.BARREAU DE MONTRÉAL \u2014BAR OF MONTRÉAL Candidats pour l'admission a l'étude du droit Candidates for the admission to the study of law Examens de janvier 1951 \u2014 Examinations of January, 1951 Nom\tPrénoms\tAge\tRésidence\tCollèges \u2014\t\u2014\t\t\u2014\t\u2014 \u201e Names\tSurnames\t\t' Residence\tColleges \t\t22 20 25 28\tMontréal.Montréal.Montréal.Montréal.\tUniversité McGill.Université McGill.Université McGill.Collège St-Laurent.\t\t\t\t \tWm.P.\t\t\t \tGuy.\t\t\t \t\t\t\t Montréal, le 19 décembre 1950 \u2014 Montreal, December 19, 1950.29046-51-2-o Le Secrétaire, W.E.BRONSTETTER, Seoretary.BARREAU DE MONTRÉAL \u2014BAR OF MONTRÉAL Candidats pour l'admission a la pratique du droit Candidates for the admission to the practice of law Examens de janvier 1951 \u2014 Examinations of January, 1951 Noms Names 1.\u2014 Beaudette.2.\u2014 Bourret.3.\u2014 Brissette.4.\u2014 Cohen.5.\u2014 Courtemanche.6.\u2014 Garmaise.7.\u2014Goulet.8.\u2014 Gonthier.9.\u2014 Gouin.10.\u2014Guilbault.11.\u2014 Lachance.12.\u2014 Laing.13.\u2014 Lefebvre.14.\u2014 McEvoy.15.\u2014 Limoges.16 \u2014Mathieu.17.\u2014NoUn.18.\u2014 Paradis.19.\u2014 Parent.20.\u2014Piper.21.\u2014 Reid.22.\u2014 Robinson.23.\u2014 Rouleau.24.\u2014 Wasserman.25.\u2014 Boucher.Prénoms Surname Raphael.Roland.s.Damase.'.Ralph A.Henri.Boris.Jean.Benoit.Gilles.Jean-Paul.Georges-Charles.J.Campbell.Yvon.John B.André-P.Guy.J.-Claude.Louis.Roger.John Trounce.- .Bernard.Pierre.Guy.Gertrude.Louise.Age Résidence Residence 40\tMontréal.23\tMontréal.24\tMontréal.27\tMontréal.34\tMontréal.29\tMontréal.27\tMontréal.33\tMontréal.24\tMontréal.32\tMontréal.24\tMontréal.25\tMontréal.24\tMontréal.\tSt-Jean, Terreneuve.26\tMontréal.25\tMontréal.27\tMontréal.25\tMontréal.23\tMontréal.24\tMontréal.25\tMontréal.24\tMontréal.27\tMontréal.44\tMontréal.24\tMontréal.Montréal, le 19 décembre 1950 \u2014 Montreal, December 19, 1950.29046-51-2-0 Le Secrétaire, W.E.BRONSTETTER, Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3291 BARREAU DE QUÉBEC \u2014 BAR OF QUEBEC Candidats poor l'admission a la pratique du droit Candidates for the admission to the practice of law Exames de janier 1951 \u2014 Examination* of January, 1951 \tNoms\t\tPrénoms\t\tRésidence \t\u2014\t\t\u2014\tAge\t\u2014 \tNames\t\tSurnames\t\tResidence \t\tJules-Henri Paul-H.\t\t25 23 24\tBeaumont, P.Q.Québec.Trois-Pistoles, P.Q.\t.».\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Québec, 23 décembre 1950 \u2014 Quebec 23rd December, 1950.Le Secrétaire du Barreau de Québec.J.-CHARLES-V.GRAVEL, 2U082-52-2:o Secretary of the Bar of Quebec BARREAU DE QUÉBEC \u2014 BAR OF QUÉBEC Candidats pour l'admission a la pratique de droit .Candidates for the admission to the practice of law \tNoms\t\tPrénoms\t\t\tRésidence \t\u2014\t\t\u2014\tAge\t\t' \u2014 \tNames\t\tSurnames\t\t\tResidence \t\t\t\t24 24 24\tQuébec.Québec.Québec.\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Québec, le 19 décembre 1950 \u2014 Quebec, December 19, 1950.Le Secrétaire du'Barreau de Québec.J.-CHARLES-V.GRAVEL, '-'9046-51-2-0 Secretary of the Bar of Quebec.BARREAU DES TROIS-RIVIÈRES \u2014 BAR OF TROIS-RIVIÈRES Candidat pour l'admission a la pratique du droit Candidate for the admission to the practice of law Examens dejanmer 1951 \u2014Examinations of January, 1951 Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tRésidence Residence\t \tGuy.;.\t22\tTrois-Rivières.\t \t\t\t\t Trois-Rivières, le 16 décembre 1950 \u2014 Trois-Rivières, December 16, 1950.Le Secrétaire du Barreau des Trois-Rivières.RICHARD RIOUX, 29046-5 l-2-o Secretary of the Bar of Trois-Rivières.BARREAU DBS TROIS-RIVIÈRES \u2014 BAR OF TROIS-RIVIÈRES Candidat pour l'admission a la pratique du droit Candidate for the admission to the practice of law Examens de janvier 1961 \u2014Examinations of January, 1951 Nom\tPrénom\t\tRésidence \u2014\t\u2014\tAge\t\u2014 Name\tSurname\t\tResidence \t\t26\tSt-Adelphe de Champlain.\t\t\t Trois-Rivières, le 23 décembre 1950 \u2014 Trois-Rivières, December 23, 1950., Le Secrétaire du Barreau des Trois-Rivières, RICHARD RIOUX, 29082-52-2-o Secretary of the Bar of Trois-Rivières. 3292 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO décembre 1950, Tome 82, N° 52 Nomination Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, et par commission, de faire la nomination suivante: Québec, 8 novembre 1950.M.Félix Houle, d'Arthabaska: shérif du district d'Arthabaska, officier spécial chargé de la confection et de la revision de la liste des jurés pour ce district et commissaire \"per dedimus po-testatem\".2907l-o Siège social Avis de la situation du siège social de \"National Chemical Exterminating Company Limited\" Avis est par les présentes donné que la \"National Chemical Exterminating Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, en date du 28 mars 1950, et ayant son siège social à Montréal, a établi son bureau à 1231 rue Stc-Cathcrine-ouest, Montréal.A compter de la date du présent avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, le 20 juillet 1950.Le Président, 29059 WILLIAM KORNPOINTNEll, jr.Appointment His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased with the advice and consent of the Executive Council and by Commission, to make the following appointment: Quebec, November 8, 1950.Mr.Félix Houle of Arthabaska: to be Sheriff of the district of Arthabaska, special officer entrusted with the making and revising list of jurors for this district and Commissioner \"per dedimus po-testaient'*.29071 Head Office Notice of the Situation of the Head Office of \"National Chemical Extermination Company Limited\" Notice is hereby given that the \"National Chemical Exterminating Company Limited\" incorporated by letters patent under Part I of Quebec Companies Act, on the 28th day of March 1950, and having its head office in Montreal, has established its office at 1231 St.Catherine St.West, Montreal.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 20th day of July, 1950.WILLIAM KORNPOINTNER, jr, 29059-o President.Soumissions Province de Québec i Ville de Scotstown (Comté de Compton) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Emile Bcaudoin, sec.-trés., C.P.159, Ville de Scotstown, comté de Compton jusqu'à 8 heures p.m., jeudi le 18 janvier 1951, pour l'achat de $50,000 d'oblipations de la ville de Scotstown.comté de Compton, datées du 1er novembre 1950 et remboursables par séries du 1er novembre 1951 au 1er nov.1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas Sy>% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut vaiier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $50,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er nov.1951.$2,000.00 1er nov.1952 .2,000.00 1er nov.1953.2,000.00 1er nov.1954 .2,000.00 1er nov.1955 .'.2,000.00 1er nov.1950 .2,000.00 1er nov.1957 .2,000.00 Tenders .Province of Quebec Town of Scotstown (County of Compton) Public notice, is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Emile Beaudoin, secretary-treasurer, P.O.Box 159, Town of Scotstown.county of Compton, up to eight o'clock in the evening, Thursday, the 18th day- of January, 1951, for the purchase of 850,000 of bonds of the town of Scotstown, county of Compton, dated the 1st of November, 1950, and redeemable serially from the 1st of November 1951, to the 1st of November, 1970 inclusively, with interest at a rate not cxeceM'ing 33^% per annum, payable semi-annually the 1st of May and 1st of November of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of Redemption \u2014 $50,000 \u2014 20 years Year Capital 1st nov.1951.$2,000.00 1st nov.1952 .2.000.00 1st nov.1953 .2,000.00 1st nov.1954 .2,000.00 1st nov.1955 .2,000.00 1st nov.1956 .2,000.00 1st nov.1957 .2,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December isOtk, 1950, Vol.82, No.52 3293 1er nov.195S.2.Q00.00 1er nov.1959 .2,300.00 ler nov.1960 .2,500.00 1er nov.1961.2,500.00 1er nov.1963 .2,500.00 1er nov.1963 .2.500.00 1er nov.1964 .2,500.00 1er nov.1965 .2,500.00 1er nov.1966 .3,000.00 1er nov.1967 .3,000.00 1er nov.19C8 .3,500.00 1er nov.1969 .3,500.00 1er nov.1970 .3,500.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Scotstown.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.* Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com-picnd ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue le jeudi, 1S janvier 1951 à 8 heures p.m., à l'endroit ordinaire des séances du conseil.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Scotstown (Comté de Compton), ce 18 décembre 1950.lie Secrétaire-trésorier, EMILE BEAUDOIN, notaire, CP.159, Scotstown, 29056-o (Compton).1st nov.1958 .2,000.Q0 1st nov.1959 .2,500.00 1st nov.1960.2,500.00 1st nov.1961 .2,500.00 1st nov.1962 .2,500.00 1st nov.1963 .2,500.00 ls* nov.1964 .2,500.00 1st nov.1965 .2,500.00 1st nov.1966 .3,000.00 1st nov.1967 .3,000.00 1st nov.1968 .3,500.00 1st nov.1969 .3,500.00 1st nov.1970 .3,500.00 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Scotstown.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1 % of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and consideicd at a meeting of the Council to be held on Thursday, the 18th day of January, 1951, at 8 o'clock p.m., at the usual meeting place of the Council.The Council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Scotstown, (County of Ccmpton), this 18th day of December, 1950.ÉMILE BEAUDOIN, notary.Secretary-Treasurer, P.O.Box 159, Scctstown, 29056 (Compton).Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Québec Ville de Lenxoxville Comté de Sherbrooke Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la ville de Lennoxville que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique au bureau du conseil municipal à l'hôtel de ville de la susdite-municipalité LUNDI, le VINT-DEUX JANVIER 1951, à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales, scolaires et intérêt mentionnées dans l'état ci-dessous et les frais qui seront subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.Raycraft, Mme Doris, subdivision 42 du lot numéro 299.Total des taxes municipales et scolaires dues $364.72.Raycraft, Mme Doris, partie du lot numéro 307.Total des taxes municipales et scolaires dues $210.70.Ces morceau ou parcelles de terre situés et se trouvant dans le village de Lennoxville et décrits comme suit: o) Le lot quarante-deux étant la subdivision du lot numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf du plan cadastral dudit village de Lennoxville Province of Quebec Towx of Lex.voxville County of Sherbrooke Public notice is hereby given by the undersigned, secretary-treasurer of the Town of Lennoxville, that the properties hereinafter described will be sold by the public auction, at the office of the Municipal Council at the Town Hall of the aforesaid municipality MONDAY the TWENTY-SECOND day of JANUARAY, 1951, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of municipal and school taxes with interest mentioned in the following statement, and the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest arid costs be paid before this sale.Raycraft, Mrs.Doris, subdivision No.42 of lot number 299.Total of municipal and school taxes due $364.72.Raycraft, Mrs.Doris, pail of lot number 307.Total of municipal and school taxes due $210.70.Those certain tracts or parcels of land, situate and being in the Village of Lennoxville and described as follows: _> a) Lot number forty-two, being the subdivision of lot number two hundred and ninety-nine, on the cadastral plan of said Village of 3294 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO décembre 1960, Tome 82, N° 52 avec toutes les bâtisses et améliorations dessus érigées et faites (42/299).b) Cette certaine partie du lot numéro trois cent sept du plan cadastral dudit Lennoxville (307) bornée comme suit: vers le nord par la rue Belvédèrcnt, vers le sud par le lot numéro quarante-deux, subdivision de deux cent quatre-vingt-dix-neuf, vers l'est par le lot numéro trois cent huit, vers l'Ouest par cette certaine partie du lot trois cent sept, telle que décrite dans ce certain procès-verbal d'arpentage devant S.E.Mead et enregistré à Sherbrooke le 4ième jour d'octobre 1910 sous le numéro 232, tome 67, avec les bâtisses et améliorations dessus érigées et faites.Y compris dans la donation, les droits de passage sur le côté ouest du terrain ci-dessus décrit, lesquels sont perpétuels en faveur du donataire; la donatrice se réserve pour elle-même personnellement le droit d'utiliser ledit droit de passage de la rue Belvédère à l'avenue Clough, mais ladite réserve est personnelle à la donatrice et ne peut pas être transférée par elle, mais il est entendu et convenu que ladite donatrice se réserve pour elle-même, ses héritiers et ayant-droits le droit d'utiliser en commun ce passage de la rue Belvédère à la grande.Les immeubles ci-dessus décrits sont tous des plans et livres de renvoi officiels du village de Lennoxville et situés dans la ville de Lennoxville.Donné sous mon seing, en la ville de Lennoxville, ce 20ème jour de décembre 1950.Le Secrétaire-trésorier, 29060-52-2-o W.R.BAKER.Canada, province de Québec, district d'Abitibi Municipalité de la ville de Val d'Or Avis public, est par les présentes donné que le Conseil de Ville de Val d'Or, par une résolution portant le numéro 4004, en date du 18 décembre 1950, a ordonné au soussigné, conformément à l'article 549 de la Loi des Cités et Villes, de vendre les immeubles ci-dessous décrits, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dependences, pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Ville de Val d'Or, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence, les dits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du Conseil, à l'Hôtel de Ville de la Ville de Val d'Or, MARDI le TRENTIÈME jour du mois de JANVIER 1951, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Toutefois seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes devenues exigibles le ou avant le 31 décembre 1948, auront été payées avant le moment de la vente.Lennox villa, with all buildings plan of said Village of Lennoxville, with all buildings and improvements thereon erected and made (42/ 299).b) That certain part of lot number three hundred and seven on the cadastral plan of said Lennoxville, (307) bounded as follows: towards the north by Belvedeie Street, towards the south by lot No forty-two, subdivision of two hundred and eight, towards the west, by that' certain part of lot three hundred and seven as described in that certain procès-verbal of survey before S.E.Mead, registered at Sherbrooke, the 4th day of October 1910, under number 232, Vol.67, with the buildings and improvenu nts thereon erected and made.Included in the donation, the rights of way on the west side of the above decribed land which are perpetual in favor of the donee; the donor reserves for herself personally the right to use said passage way from Belvedere street, to Clough Avenue, but.said reserve is i>ersonal «to the donor and cannot be transferred by her but it is understood and agreed that the said donor reserves for herself, her heirs and assigns the right to use in common that driveway from Belvedere street to the barn.The above immoveable are all upon the official plan and in the book of reference of the Village of Lennoxville, and situated in the Town of Lennoxville.Given under my hand, in the Town of Lennoxville, this 20th day of December, 1950.W» R.BAKER, 29060-52-2-o Secretary-Treasurer.Canada, province of Quebec, district of Abitibi.The Municipality of the Town of Val D'Or Public notice is hereby given that the Town Council of .Val d'Or, by a resolution bearing number 4004 dated the 18th of December 1950, has ordered the undersigned, pursuant to the provision of article 549 of the Towns and Cities Act, to sell the immovables hereinbelow described, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies in payment of arrears of taxes due to the Town of Val d'Or, with interests and costs, and that consequently, the said immovables will be sold by public auction in the Council Hall at the Town Hall of the Town of Val d'Or, on TUESDAY the THIRTHIETH dav of the month of JANUARY 1951, at HALF past TEN o'clock in the forenoon.However there shall be excluded from the sale, those immovables whereon the taxes falling due on or before the 31st of December 1948, shall have been paid before the sale.Nom Name 4\tNo.du- cadastre Cadastral Number\tTaxes\tIntérêts et frais Interests and costs\t* Total \t34-257 34-258\t$523.23 773.30\t$ 33.55 62.90\t$550.78 836.20 La vente des immeubles décrits dans le présent The sale of the immovables described in the avis est faite, s'il y a lieu, sujette aux conditions present notice is made as the case may be, sub- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3295 des baux emphythéotiques pouvant affecter ject to the conditions of emphyteutic leases lesdits immeubles.which may affect the said immovables.le prix d'adjudication de chacun de ces im- The purchase price of each of the said immo-mcubles sera payable immédiatement.vables will be payable immediately.Donné a Val d'Or, Que.ce dix-neuvième Given at Val d'Or, this nineteenth day of jour de décembre 1950.December 1950.Le Greffier, J.A.NADON, 29061-52-2-o .1.A.NADON.29061-52-2-0 Town Clerk.VENTES PAR SHÉRIFS SHERIFFS* SALES AVIS rUBLIC est par le présent donné que PUBLIC NOTICE, is hereby given that th»\" les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.HULL HULL Cour Supérieure \u2014 District de Hull Superior Court \u2014 District of Hull / T3 ONALD ST.LAURENT, gardien- / T3 ONALD ST.LAURENT, warden N° 125.< commis, des cité et district de No.125.< and clerk, of the city and district I Hull, tant personnellement qu'en sa \u2022 \\ of Hull, \"both personally and as heir qualité d'héritier de son père, feu Joseph Octave to his father, the late Joseph Octave St.Laurent St-Laurent, de son vivant des mêmes lieux, in his lifetime.of the same place, plaintiff; vs demandeur vs RENÉ EMMANUEL ST.LAU- RENE EMMANUEL ST.LAURENT, of the RENT, de la cité de New-York dans l'État de city of New York, in the State of New York, one New-York, l'un des États-Unis.d'Amérique; of the United States of America; ARSENE ARSENE ST.LAURENT, de la Cité de Détroit, ST.LAURENT, of the city of Detroit, in the dans l'état de Michigan, l'un des États-Unis State of Michigan, one of the United States of d'Amérique; JEANNE ST.LAURENT, épouse America; JEANNE ST.LAURENT, wife of de J.A.Major et ce dernier pour autoriser son J.A.Major, and the latter to authorize his wife épouse aux fins des présentes, tous deux de la for the purposes hereof, both of the city of cité d'Ottawa, dans la province d'Ontario, et Ottawa, in the Province of Ontario, and Dame Dame MARIE-ANGE CYR, veuve de Octave MARIE ANGE CYR, widow of Octave Provin Provin St.Laurent de l'endroit appelé Cyrvillc, St.Laurent, of the place called Cyrville, in the dans la province d'Ontario, tous tant personnel- Province of Ontario, all both personally and as lement qu'en leur qualité d'héritier de leur père heirs to their father, the said J.Octave St.Lau-ledit J.Octave St.Laurent, en son vivant des rent, in his lifetime of the city and district of cité et district de Hull, défendeurs, et RODRI Hull, defendants; and RODRIGUE BÉDARD GUE BÉDARD, avocat et conseiller en loi du advocate and King's Counsel, of the city and dis-Roi, des cité et district de Hull, distrayant.trict of Hull, distracting for costs.1° Tout ce lot ou morceau de terre composé 1.All that lot or parcel of land composed of de la moitié Est du lot numéro soixante-quinze the East half of lot number seventy-five on the du cadastre pour le quartier numéro trois de la cadastre for the Ward number three of the city of cité de Hull, borné comme suit: \u2014 En front vers Hull, bounded as follows: In front, towards the le sud par la rue St.Etienne, vers l'est par'la south by St.Etienne street, on the east by St rue St.Henri, vers l'ouest parla moitié ouest du Henri street, on the west, by the west half of said lot soixante-quinze et vers le nord par la ligne lot seventy-five and on the north by the division de division entre ledit lot soixante-quinze et line between said lot seventy five and lot number le lot numéro soixante-huit du même quartier, sixty-eight of the same ward, or by the lot of land ou par le terrain ci-après décrit; hereinafter described ; 2° Tout ce morceau de terre composé du quart 2.All that parcel of land composed of the sud-est du lot numéro soixante-huit dudit quar- southeast quarter of lot number sixty-eight of tier numéro trois de la cité de Hull, borné said Ward number three of the city of HuU comme suit: vers l'Est par la rue St.Henri, vers bounded as follows: towards the east by St.Henri le nord par le quart nord-est dudit lot soixante- street, towards the north by the northeast quarter huit, vers l'Ouest par le quart sud-ouest dudit of said lot sixty-eight, towards the west by the lot soixante-huit et vers le sud, par le terrain southwest quarter of said lot sixty-eight and to-ci-dessus en premier Keu décrit.wards the south by the lot of land above firstly described.Les dits deux morceaux de terre mesurant These two parcels of land measure together ensemble quarante-huit pieds et demi dans les forty-eight feet and one half in the north and lignes nord et sud par quatre-vingt-dix-neuf pieds south lines by ninety-nine feet in the cast and dans les lignes est et ouest, le tout plus ou moins, west lines, the whole more or less, with all the avec toutes les bâtisses dessus érigées, circons- buildings thereon erected, circumstances and tances et dépendances.dependencies.Pour être vendus en bloc, au bureau du Shérif To be sold \"en bloc\" at the Sheriff's Office, in au Palais de justice, en la cité de Hull le 19 the Court House, in the city of Hull, on the JANVIER 1951 à DIX heures de l'avant-midi.NINETEENTH day of JANUARY, 1951, at TEN o'clock in the forenoon.Le Shérif, I.ST-PIERRE, Bureau du Shérif, I.ST-PD3RRE Sheriff's Office, Sheriff.Hull, le 5 décembre 1950.28953-49-2-o Hull, December 5, 1950 28953-49-2 [Première insertion: 9 décembre 1950] , [First Insertion: December 9, 1950] 3296 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 80 décembre 1950, Tome 82, N° 52 KAMOURASKA Fieri Farias de Terris Cour Supérieure Canada, (TB.LA VOIE, avo- Province de Québec, ÏJ» cat de la cité de District de Kamouraska j Rivière - du - Loup, de-N° 16576 l mandera vs WIL- LIAM CLOUTIER, du même lieu, défendeur.\"La partie de lot N° 940, au cadastre officiel de la paroisse de St-Patrice de Rivière-du-Loup, mesurant cinquante (50) pieds de front sur quatre-vingt-dix (90) de profondeur, mesure anglaise, borné au Nord au chemin public, au Sud à Roland D'Amours, à l'Est à Georges St-Pierre, et «à l'Ouest à Charles Cloutier.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse St-Patrice de Rivière-du-Loup, MERCREDI, TRENTE ET UNIÈME jour du mois de JANVIER, 1951 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, 19 décembre 1950.29070-52-2-o [Première insertion : 30 décembre 1950] KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Superior Court Canada, (TB.LA VOIE, ad- Province of Quebec, 1J \u2022 vocate, of the city District of .Kamouraska j of Rivière - du - Loup, No.16576 (plaintiff; vs WIL- LIAM CLOUTIER, of the same place, defendant.The part of lot No.940, on the official cadastre for the parish of St-Patrice de Rivière-du Loup, measuring fifty (50) feet in front by ninety (90) feet in depth, English measure, bounded on the north by the public road, on the south by Roland D'Amours, on the east by Georges St-Pierrc, and on the west by Charles Cloutier.The whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold, at the church door of the parish of St-Patrice de Rivière-du-Loup, on WEDNESDAY, the THIRTY-FIRST day of the month of JANUARY, 1951, at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, December 19, 1950.[First insertion: December 30, 1950] MONTMAGNY MONTMAGNY Fieri Farias de Bonis et de Terris Cour du Magistrat District de Montmagny, /TÉLÉS P H ORE N° 15114.-j A COULOMBE, (négociant, de la ville de Montmagny, demandeur, vs PAUL-EMILE GIASSON, du quartier industriel, ville de Montmagny, district de Montmagny, défendeur.Une maison en bois construite sur un emplacement connu et désigné au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny partie annexée à la ville de Montmagny, comme étant partie du lot numéro soixante-et-onze (71) de onze cent soixante-neuf (1169) et partie du lot numéro sept cent cinquante-sept (757) de onze cent soixante-neuf (1169), ledit emplacement étant la propriété dudit Télesphore Coulombc.Pour être vendue à la porte de l'église de Saint-Thomas de Montmagny, le SEIZIÈME jo-ir de JANVIER 1951, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du shérif, J.-ERNEST BERNIER.Montmagny, le 4 décembre 1950 28959-49-2-o [Première insertion: 9 décembre 1950] QUÉBEC Fieri Farias Cour de Magistrat Québec, à savoir: / A IMÊ PARENT, de la N° 117-130.< ville de Beauport, bou-{ cher, contre LIONEL DION-NE, de la ville de Beauport, huissier, à savoir: La subdivision N° 31 (trente-et-un) du lot N° 468 (quatre cent soixante-huit) et la subdivision Nb 26 (vingt-six) du lot N° 473 (quatre cent soixante-treize) du cadastre officiel pour la paroisse de Beauport, comté de Québec, formant un emplacement situé rue Saint-Cléophas, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendues à la porte de l'église parois-, siale de Beauport, comté de Québec, le DIX- Ficri Facias de Bonis et de Terris Magistrate's Court District of Montmagny / HP' É L E S P H O R E No.15114.< *¦ COULOMBE, lof the town of Montmagny, plaintiff vs PAUL-ÉMILE GIASSON, industrial district, town of Montmagny, district of Montmagny, defendant.A wooden house situate on an emplacement known and designated upon the official cadastre of the parish of St-Thomas of Montmagny, being now annexed to the town of Montmagny, as a subdivision of lot number seventy-one (71) of eleven hundred and sixty-nine (1169) and subdivision of lot number seven hundred and fifty-seven (757) of eleven hundred and sixty-nine (1169), the said emplacement being the property of the said Télesphore Coulombe.To be sold, at the church door of St-Thomas of Montmagny, on the SIXTEENTH dav of JANUARY 1951, at TEN o'clock of the forenoon.J.ERNEST BERNIER, Sheriff Office, Sheriff.December 4.1950.28959-49-2*) [First insertion: December 9, 1950] QUEBEC Fieri Facias Magistrate's Court Quebec, to wit : l A IME PARENT, of the No.117-130.< arts of the same lot belonging to Mr.Gabriel Hurtcau \u2014 with buildings thereon erected.\" To be sold, at mv office, in the citv of Sorel, on the FIRST day of FEBRUARY 1951, at ELEVEN o'clock in the forenoon.R.PAQUIN, Sheriff's Office, Sheriff.Sorel, December 20, 1950.[First insertion: December 30, 1950] 3298 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 TERREBONNE Cour Supérieure Canada, ( T-JO RACE G A - Province de Québec, ) A J.G N I E R, pein-District de Terrebonne ) tre de Saint-Eustachc-N° 20,119.(sur le Lac, district de Terrebonne, demandeur, vs ST-EUSTACHE BOATING CLUB LIMITED, corporation a-yant sa principale place d'affaires à Saint-Eus-tache sur le Lac, district de Terrebonne, défendeur.Avis est par la présente donné que la vente des immeubles saisis dans la présente cause qui devait avoir lieu le 27 décembre 1950, à deux-heures de l'après-midi, à la porte de l'église \\ic Saint-Eustache sur le Lac, aura lieu à la porte de l'Église catholique de Saint-Eustache sur le Lac le TRENTE JANVIER 1951 à DEUX heures de l'après-midi.LeShéiiff, Bureau du Shérif, ALBERT FOURNELLE.St-Jérôme, ce 19e jour de décembre 1950.2908 l-o TERREBONNE Superior Court Canada, ( T_TO RACE G A - Province of Quebec, )J-*GNIER, painter District of Terrebonne, \\ of St.Eustache sur le No.20,119 (Lac, district of Terrebonne, plaintiff, vs ST.EUSTACHE BOATING CLUB\" LIMITED, corporation having its principal place of business at St.Eustache sur le Lac, district of Terrebonne, defendant.Notice is hereby given that the sale of the immoveables seized in the present case which was to take place on December 27th 1950, at the church door of St.Eustache sur le Lac et two o'clock in the afternoon; will take place at the church door of St.Eustache sur le Lac on JANUARY the THIRTIETH 1951, at TWO o'clock in the afternoon.ALBERT FOURNELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Saint-Jérôme, December the 19th.1950.29081-o TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Terris Cour Supérieure Canada, ,pHILlPPE GI- Province de Québec, l X MAIEL, direc-District des Trois-Rivières, < teur général de la No.10,355.f taxe de vente de la ^ province de Québec, domicilié à 05 rue Ste-Julie,'Québec, demandeur, vs LOUIS BOULIANNE, 203, rue Rochefort, Cap de la Madeleine, défendeur.\"Un emplacement situé sur la Septième rue, aujourd'hui connue sous le nom de rue Dcssu-reault, en la cité du Cap de la Madeleine, de la contenance de quatre-vingt-dix pieds de largeur sur la profondeur qu'il y a de la dite rue à la ligne de transmission électrique, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Marie du Cap de la Madeleine, comme étant partie du lot numéro Trois cent quatre-vingt-sept (P.3S7) et borné comme suit: en front, par la septième rue; en profondeur, par la ligne de transmission elect rique; d'un côté à l'euest, par la ruelle (No.769) et.de l'autre côté, vers l'est, p^r dame Pierre Rochefort, avec maison et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; à distraire, cependant dudit emplacement la partie de trente pieds de front par cent dix pieds de profondeur enviion, vendue à monsieui Lionel Thivierge, suivant acte reçu devant Me J.A.D.Chagnon, notaire, le 16 décembre 1940, et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement du comté de Champlain, sous le N° 110621 \".Pour être vendu, à la porte de l'église Sainte-Marie Madeleine, en la cité du Cap de la Madeleine, MARDI, le TRENTIÈME jour de JANVIER, 1951, à DIX heures du matin, Le Shérif, Bureau du Shérif, L.P.MERCIER.Trois-Rivières, le 26 décembre 1950.29085-52-2-o [Première insertion: 30 décembre 1950] TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Terris Superior Court Canada, ,pHILIPPE GI- Province of Quel)ec, ( MAIEL, general District of Trois-Rivières, < director of the sales No.10,355.I tax of the Province ^of Quebec, domiciled at 65, Ste-Julie Street, Quebec, plaintiff; vs LOUIS BOULIANNE, 203 Rochefort Street, Cap de la Madeleine, defendant.\"An emplacement si*uate on Seventh Street, snow known under the name of Dessureault Street, in the city of Cap-de-la-Madelcinc, measuring ninety feet in width by the depth which three may be from the said street to the electric transmission line, known and designated on the official plan and in the book of reference of the parish of Ste-Marie du Cap-de-la-Madeleine, as being part of lot number three hundred and eighty-seven (Pt387) and bounded as follows: in front by Seventh Street, on the depth by the electric transmission line; on one side on the west by the lane (No.769) and on the other side, towards the east by Dame Pierre Rochefort \u2014 with a house and other buildings'thereon erected, circumstances and dependencies; to be deducted however from said emplacement that part of thirty feet in front by about one hundred and ten feet in depth, sold to Mr.Lionel Thivierge, as per deed received before Me J.A.D.Chagnon, notary, on December 16, 1940, and copy whereof was registered in the Office of the Registration Division of the county of Champlain under No.110621\".To be sold at the church door of Sainte-Marie Madeleine, in the citv of Cap-de-la-Madeleine, on TUESDAY, the THIRTIETH day of JANUARY, 1951, at TEN o'clock in the forenoon.L.P.MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.Trois-Rivières, December 26, 1950.29085-52-2 [First Insertion: December 30, 1950] QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 30th, 1950, Vol.82, No.52 3299 Index de la Gazette officielle Index of the Quebec Official de Québec, Na 52 Gazette, No.52 ACTIONSvEN séparation de biens: Boivin vs Plante.3276 Fortin vs Lebeau.3276 Vasilion vs Rethmetakos.3276 Arrête en Conseil: 1368, section \"A\" \u2014 Industrie et mér tiers de la construction dans les comtés d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et al.3277 Avis aux intéressés: Avis divers: Association des Infirmières diplômées de l'Hôpital Notre-Dame.(Changement de nom) .__.3280 Collin's & Sons (Veneers) Limited\u2014Les Placages Collin Limitée (Directeurs).3278 La Manufacture de Meubles de Montmagny, Limitée \u2014 Montmagny Furniture Co.Limited (Directeurs)____.3280 Les Pétroles Inc.(Directeurs).3279 Les Produits Forestiers Collin (Ltée) \u2014 Collin Lumber (Ltd.) (Directeurs).3280 Le Syndicat Coopératif de Magog (Fondation).3280 Monitor Publishing Company Limited (Directeurs).3279 Perco Realty Inc.(Distribution de l'actif).3281 St-Honoré, paroisse de (Tirage d'obligations) .3278 The Polish War Veterans Society of Marshal J.Pilaudski Inc.(Directeurs) 3278 .Trans-Canada Export Limited (Distribution de l'actif).3281 Wrexham Investments Limited (Distribution de l'actif).3279 Bills, Assemblée législative: Concernant les bills privés qui seront présentés au cours de la présente session.3281 Chartes \u2014 Abandon de: Fairmount Investment Corporation.3281 Hôpital Bellevue Inc.3281 Wrexham Investments Limited.3282 Compagnie autorisée a faire des affaires: Stuyvesant Industries Inc.3282 Demandes X la Législature: Black Lake, ville de.3287 Drummondville, cité de.3283 Girard, Dame Anna.3285 Grand'Mère, cité de et al.3284 LaSalle, ville de.3286 Les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de Mont-Laurier.3283 L'Institut des Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne.3285 Montréal, Bureau central des écoles protestantes de.3284 Actions for Separation as to Property: Boivin vs Plante.3276 Fortin vs Lebeau.3276 Vasilion vs Rethmetakos.3276 Order in Council: 1368, part \"A\" \u2014 Construction industry and trades in the counties of Abitibi-East, Abitibi-West et al.3277 Miscellaneous Notices: Association des Infirmières diplômées de l'Hôpital Notre-Dame (Change of name).3280 Collin's & Sons (Veneers) Limited \u2014 Les Placages Collin Limitée (Directors).3278 La Manufacture de Meubles de Montmagny, Limitée \u2014 Montmagny Furniture Co.Limited (Directors).3280 Les Pétroles Inc.(Directors).3279 Les Produits Forestiers Collin (Ltée) \u2014 Collin Lumber (Ltd.) (Directors).3280 Le Syndicat Coopératif de Magog (Foundation).3280 Monitor Publishing Company Limited (Directors).32?9 Perco Realty Inc.(Distribution of the assets).3281 St-Honoré, parish of (Drawing of bonds).3278 The Polish War Veterans Society of Marshal J.Pilaudski Inc.(Directors).3278 Trans-Canada Export Limited (Distribution of the assets).3281 Wrexham Investments Limited (Distributions of the assets).3279 Bills, Legislative Assembly: Relating to private bills to be introduced during the present session.3281 Fairmount Investment Corporation .3281 Hôpital Bellevue Inc.3281 Wrexham Investments Limited.3282 Company Licensed to do Business: Stayvesant Industries Inc.3282 Black Lake, town of.3287 Drummondville, city of.3283 Girard, Dame Anna.3285 Grand'Mère, city of et al.3284 LaSalle, town of.3280 Les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de Mont-Laurier.3283 L'Institut des Sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne.3285 Montreal, Protestant Central School Board.3284 3255 Notice to Interested Parties: 3255 Charters \u2014 Surrender of: Applications to Legislature: 3300 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Montréal, Bureau des commissaires des écoles protestantes de la cité de.3286 Perron Gold Mines Limited.3283 Plessisville, commissaires d'école de .3283 Sillery, cité de.\u2022.3282 St-Laurent, ville de.3286 Ste-Rose, ville de.3285 Succession Henri Legault.3284 Succession Hugh Quinlan.3284 Succession Réal Lamontagne.3287 DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Agriculture: Industrie Laitière: Ordonnance N° 7-50A \u2014 Rivière-du-Loup.3288 Travail: Métiers de plombiers et de poseurs d'appareils de chauffage dans les comtés de Maskinongé, St-Mauricc et al ' (Modification).32S8 Examens du Barreau: Bas St-Laurent: pratique «lu droit.3287 Montréal: pratique du droit.3290 Montréal : étude du droit.3290 Montréal: pratique du droit.3290 Québec: pratique du droit,.3291 Québec: pratique du droit.3290 Trois-Rivières: pratique du droit.3291 Trois-Rivières: pratique du droit.3291 Lettres patentes: Agences Rama Agencies Inc.2256 Automatic Dispensers Manufacturing Ltd.2257 Ayers-Cliff Wood Products Limited.3257 Ben Lewis Incorporated.3257 Brown Boveri Realty Corporation .3258 Brownstein Realties Inc.3258 Capital Dress Limited.3258 Century Stainless Steel Company Limited.3259 Chap and Ma Construction Inc.3259 Chavigny Mines Limited.3259 Club de Baseball Saint-Jean Limitée.3260 Clubs Juvéniles du Comté de Drummond Inc.3260 C.Roland Champeau Ltée.3261 Eastern Containers Ltd.3261 Exclusive Silks Inc.3261 Grovedale Construction and Realty Co.Ltd.3262 Hector Investments Limited .3262 Humane Society of Deschênes.3262 Imanuel Langer Limited.3263 J.A.Poissant et Fils Ltée.3263 J.A.St.Laurent Limited.3263 Jos.Dupuy Inc.3264 Les Autobus Boulais Lim tée.3264 Loup's Inc.'.3264 L.Young Sportswear Inc.3265 Marc Motor Cars & Repairs Ltd.3265 Michel Rodin Inc.3265 Midway Industries Ltd.3266 Nordic Oil Ltd.3266 Omega Electric Co.Ltd.3266 Montreal, Protestant Board of School Commisssioners of the City of.3286 Perron Gold Mines Limited.3283 Plessisville, School Commissioners of 3283 Sillery, city of.3282 St-Laurent, town of.r.3286 Ste-Rose, town of.3285 Estate of Henri Legault.3284 Estate of Hugh Quinlan.3284 Estate of Real Lamontagne.3287 DEPARTMENTAL NOTICES: 3287 Agriculture: Dairy Industry: Order No.7-50A \u2014 Rivière-du-Loup.3288 Labour: Plumbing and stca,mfitting trades in the counties of Maskinongé, SV Maurice et al (Amendment).3288 Lower St.Lawrence: practice of law.3287 Montreal: practice of law.3290 Montreal : study of law.3290 Montreal: practice of law.3290 Quebec: practice of law.3291 Quebec: practice of law.3290 Trois-Rivières: practice of law.3291 Trois-Rivières: practice of law.3291 Letters Patent: Agences Rama Agencies Inc.3256 Automatic Dispensers Manufacturing Ltd.3257 Ayers-Cliff Wood Products Limited.3257 Ben Lewis Incorporated.3257 Brown Boveri Realty Corporation .3258 Brownstein Realties Inc.3258 Capital Dress Limited.3258 Century Stainless Steel Company Limited.3259 Chap and Ma Construction Inc.3259 Chavigny Mines Limited .3259 Club de Baseball Saint-Jean Limitée.3260 Clubs Juvéniles du Comté de Drummond Inc.3260 C.Roland Champeau Ltée.3261 Eastern Containers Ltd.3261 Exclusive Silks Inc.3261 Grovedale Construction and Realty Co.Ltd.3262 Hector Investments Limited.3262 Humane Society of Deschênes.3262 Imanuel Langer Limited.3263 J.A.Poissant et Fils Ltée.3263 J.A.St.Laurent Limited.3263 Jos.Dupuy Inc.3264 Les Autobus Boulais Limitée.3264 Loup's Inc.\u2022-.- 3264 L.Young Sportswear Inc.3265 Marc Motor Cars & Repairs Ltd.3265 Michel Rodin Inc.3265 Midway Industries Ltd.3266 Nordic Oil Ltd.3266 Omega Electric Co.Ltd.3266 Affaires Municipales: Municipal Affairs: _ Notre-Dame de Lourdes de Ham, pa- Notre-Dame de Lourdes de Ham, paroisse de.3287 rish of.Bar Examinations: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December SOth, 1950, Vol.82, No.52 3301 Pépin & Fils Limitée.3267 P.M.Cinq-Mars Inc.3267 P.P.Masson Limitée.3267 Precision Panels Inc.3268 Preferred Sportswear Manufacturers Inc.3268 Québec Éditions Inc.3268 Rodrigue Lasnier Automobile Limitée.3269 St-John Café Incorporated \u2014 Café St-Jean Incorporée.3269 St.Regis Mines Limited.3270 The Baie Label Company Inc.3270 The Kiwanis Club of Thetford Mines, Inc.\u2014 Le Club Kiwanis de Thetford Mines, Inc.3270 Trans-Provincial Communication Inc.2171 Vince Woodcraft, Limited.3271 Lettres patentes supplémentaires: Beauregard Fur Corporation Limited.3272 Crémerie ces Trois-Rivières, Limitée .3272 Dexter Shoe Company Limited.3272 Eastern Clothing Co.Ltd.3273 Les Editions du Réveil Ltée.3273 L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Montmagny Inc.3273 Marvel Machine Works Limited.3273 * Montreal West Hardware Company Incorporated.3274 National Laboratories Limited.3274 Parkdale Homes Development Corp.3274 Queen City Dress Company Limited .3274 Sport Togs Limited .____.3275 The Bras d'Or Bay Navigation Company Limited.3275 The MacGregor Paper & Bag Company, Incorporated.3275 The Main Fish Company Limited.3276 The Royal Store, Limited.3276 Pépin & Fils Limitée.3267 P.M.Cinq-Mars Inc.3267 P.P.Masson Limitée.3267 Precision Panels Inc.3268 Preferred Sportswear Manufacturers Inc.3268 Québec Editions Inc.3268 Rodrigue Lasnier Automobile Limitée.3269 St-John Café Incorporated \u2014 Café St-Jean Incorporée.3269 St.Regis Mines Limited.3270 The Baie Label Company Inc.3270 The Kiwanis Club of Thetford Mines, Inc.\u2014'Le Club Kiwanis de Thetford Mines, Inc.3270 Trans-Provincial Communication Inc.3271 Vince Woodcraft, Limited.« 3271 Supplementary Letters Patent: Beauregard Fur Corporation Limited.3272 Crémerie des Trois-Rivières, Limitée .3272 Dexter Shoe Company Limited.3272 Eastern Clothing Co.Ltd.3273 Les Editions du Réveil Ltée.3273 L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Montmagny Inc.3273 Marvel Machine Works Limited.3273 Montreal West Hardware Company Incorporated.3274 National Laboratories Limited.3274 Parkdale Homes Development Corp.3274 Queen City Dress Company Limited .3274 Sport Togs Limited.3275 The Bras d'Or Bay \"Navigation Company Limited.3275 The MacGregor Paper & Bag Company, Incorporated.-.3275 The Main Fish Company Limited.3276 The Royal Store, Limited.3276 Nomination: Appointment: Houle, Félix.3292 Houle, Félix.3292 Siège social: Head Office: National Chemical Exterminating Company Limited.3292 National Chemical Exterminating Company Limited.3292 Soumission: Tender: Scotstown, ville de.3292 Scotstown, town of.3292 Ventes pour taxes: Lennoxville, ville de.Val d'Or, ville de .Sales for Taxes: 3293 Lennoxville, town of.3293 3294 Val d'Or, town of.3294 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Hull: Hull: St-Laurent vs St-Laurent et ,al.3295 St-Laurent vs St-Laurent et al.3295 \\ K amourask a : .kamour ask a : Lavoie vs Cloutier.3296 La voie vs Cloutier.3296 Montmagny: Montmagny: Coulombe vs Giasson.3296 Coulombe vs Giasson.3296 Québec: Cité de Québec vs Boissonneault.3297 Parent vs Dionne.3296 Quebec: City of Quebec vs Boissonneault.3297 Parent vs Dionne.3296 3302 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 décembre 1950, Tome 82, N° 52 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Ré demit i Paradis, imprimeur du Roi.King's Printer.Richelieu: Richelieu: Lacroix vs Lusignan et al.3297 Lacroix vs Lusignan et al.3297 Terrebonne: Terrebonne: Gagnier vs St-Eustache Boating Club Gagnier vs St-Eustachc Boating Club Limited.3300 Limited.3300 Trois-Rivières: Trois-Rivières: Gimaiel vs Boulianne.3300 Gimaiel vs Boulianne.3300 29087-o 29087-o "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.