Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 17 (no 7)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1951-02-17, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 83, N° 7 609 Vol.83, No.7 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubushed by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Quebec, samedi 17 février 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.^ .4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception] et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, February 17th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be pubilshed several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.i 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 610 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1961, Tome 88, N° 7 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insert ion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 îa douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à.notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remit- ' tances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a \"typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 wards.Single copies : 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMFPI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u20141-52 Lettres patentes Letters Patent Abe Rosenberg Furs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois janvier 1951, constituant en corporation: Abe Rosenberg, marchand de fourrures, Sylvia Aronovitz Rosenberg, épouse séparée de biens de Abe Rosenberg et Philip S.Garonce, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: .Exercer le' commerce comme marchands de toutes sortes de fourrures; manufacturer et faire le commerce d'aucun et tous articles vestimentaires et d'habillement, sous le nom de \"Abe Rosenberg Furs Ltd.\", avec un capital de $80,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et en 4,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 363 rue Concord, Montréal, district judiciaire de Montréal.Abe Rosenberg Furs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1951, incorporating: Abe Rosenberg, fur merchant, Sylvia Aronovitz Rosenberg, wife separate as to property of Abe Rosenberg, and Philip S.Garonce, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of dealer in all kinds of furs; to manufacture and deal in any and all articles of clothing and wearing apparel, under the name of \"Abe Rosenberg Furs Ltd.\", with a capital stock of $80,000 divided into 400 common shares of $100 each, and 4,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 363 Concord Street, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 611 Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Acme Pad Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf décembre 1950, constituant en corporation: Charles Brownstein, avocat, Betty Pome-rantz et Mary Steiman, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et faire le commerce de vêtements et accessoires, sous le nom de \"Acmfe Pad Co.Ltd.\", avec un capital de $30,000 divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 2,700 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1950.\u2022 - L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Association Industrielle de Ville St-Laurent Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Aaron Baylin, manufacturier, Charles Patrick de Volpi, George William Millar, gérants et Edouard O'Donoug-hue, secrétaire-trésorier, Richard Pfizenmaier, gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir, encourager et protéger les intérêts de l'industrie, du négoce et du commerce et le bien-être économique, civique et social de Ville St-Laurent, district de Montréal, et environs, sous le nom de \"Association Industrielle de Ville St-Laurent.\" Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Ville St.Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, a 29463 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Acme Pad Co.Lid.Notice is hereby given that under Part I of the Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1950, incorporating: Charles Brown-stein, advocate, Betty Pomerantz and Mary Steiman, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufactuie and deal in clothing apparel and accessories, under the name of \"Acme Pad Co.Ltd.\", with a capital stock of $30,000 divided into 3,000 common shares of the par value of $1 each, and 2,700 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Association Industrielle de Ville St-Laurent Notice is hereby given that under the Provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1951, incorporating without share capital : Aaron Baylin, manufacturer, Charles Patrick de Volpi, George William Millar, managers, and Edouard O'Donoughue, secretary-treasurer, Richard Pfizenmaier, manager, all of the city and judicial district of Montreal for the following purposes: To promote, advance and protect the interests of industry, trade and commerce and the economic, civic'and social welfare of the Town of St.Laurent in the district of Montreal and vicinity, under the name of \"Association Industrielle de Ville St-Laurent\".The amount to wlucli the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited is $50,000.The head office of the corporation will be at Ville St-Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of Januarv, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Bible Institute of Montreal Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize décembre 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Herbert Britton, assistant agent général, dormants et bois, Chemin de fer Canadien National, de Verdun, Révérend Paul Chodat, de Montréal, Gladys Janet, professeur de la bible, épouse commune en biens de Aimé-Paul Duchesneau, de Westmount, Henry Gray Foreman, (rentier), assistant-trésorier, de Westmount, Reverend Aimé-Paul Duchesneau, de Westmount, Révérend Stanley Sage Stock, Joseph Irving Duguid, comptable, Chemin de fer Canadien Pacifique, tous deux de Montréal, Violette Delagneau, profes- Bible Institute of Montreal Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1950, incorporating without share capital: Herbert Britton, Assistant general Tie and Timber Agent, Canadian National Rys, of Verdun, Reverend Paul Chodat, of Montreal, Gladys Janet, bible teacher', wife common as to property of Aimé-Paul Duchesneau, of Westmount, Henry Gray Foreman, (retired) Assistant-treasurer, of Westmount, Reverend Aimé-Paul Duchesneau, of Westmount, Reverend Stanley Sage Stock, Joseph Irving Duguid, accountant, Canadian Pacific Railway, both of Montreal, Violette Delagneau, teacher, wife common as to property of Eugène John Lefebvre, me- 612 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 seur, épouse commune en biens de Eugène John Lefebvre, ingénieur mécanicien et dûment autorisée par lui, de la cité de Westmount et Sydney Clyde Welby, agent général du combustible, Chemin de fer Canadien National, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Former des hommes et des femmes devant s'occuper d'oeuvres chrétiennes de toutes sortes, sous le rom de \"Bible Institute of Montreal Inc.\" Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que l'Institut peut posséder-est de S100.C00.\" Le siège social de la corporation sera à Montréal, district ju.liiiaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Block Equipment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la\" première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Q îébec, des lettres patentes en date du huit janvier 1951, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, avocat, de Westmount, Jack Lightstone, avocat, et Yvonne Bélanger, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du dist'ict j.idiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et faire le négoce de métaux de toutes sortes; exercer le commerce comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Block Equipment Corporation\".* Le capital d; la compagnie sera composé de 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et de 3,009 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune, et le montant minimum avec lequel la compagnie exercera son commerce sera de $8,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Canadian Import Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept décembre 1950, constituant en corporation: Claude Sartoris Richardson, avocat et conseil en loi du Roi, Ernest William Mockridge, gérant, William Patrick Creagh, commis en loi, Clifford George Meek, teneur de livres et Albert Edward Liddell, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de charben, coke, tourbe, bois et toutes sortes de combustible, sous le nom de \"Canadian Import Company\".Le capital de la compagnie sera composé de 80,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et de 50,000'actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie exercera son commerce sera de $1,050,000.Le siège sccial de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept déceïribre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.chanical engineer, and duly authorized by him, of the city of Westmount, and Sydney Clyde Welby, general fuel agent, Canadian National Rys., of Verdun, all in Hie judicial district of Montreal, for the following purposes: To train men and women for Christian work of all kinds, under the name of \"Bible Institute of Montreal Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the Institute may possess is to be limited to $100,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December, 1950.L.DÉSILETS, 29463-0, Deputy Attorney General.Block Equipment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1951, incorporating: Philip Fischel Vineberg, advocate, of Westmount, Jack Lighstone, advocate, and Yvonne Bélanger, secretary, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and deal in metals of all kinds; to carry on the business of general contractors, under the name of \"Block Equipment Corporation\".The capital stock of the company shall consist of 1,000 common shaies without nominal or par value, and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each, and the minimum amount with which the company will carrv on business will be $8,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Canadian Import Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Provinr ce of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of December, 1950, incorporating: Claude Sartjris Richardson, advocate and King's Counsel, Ernest William Mockridge, manager, William Patrick Creagh, law clerk, Clifford George Meek, bookkeeper, and \"Albert Edward Liddell, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in coal, coke, peat, wood and all kinds of fuel, under the name of \"Canadian Import Company\".The capital stock of the company shall consist of 80,000 preferred shares of the par value of $100 each, and 50,000 common shares without nominal or par value, and the amount with which the company shall carry on its business shall be $1,050,000 The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol 83, No.7 613 Carlton Upholstering Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf janvier 1951, constituant en corporation: Louis Rabinovitch, marchand, Lily Berlin Rabinovitch, ménagère, épouse séparée de biens du dit Louis Rabinovitch, Harry Tobenstein, marchand, et Fay Rabinovitch Tobenstein, ménagère, épouse séparée de biens dudit Harry Tobenstein, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme rembourreurs, travailleurs en beis, ébénistes et décorateurs d'intérieurs, sous le nom de \"Carlton Upholstering Co.\" avec un capital de $30,000 divisé en 3,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Carlton Upholstering Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1951, incorporating: Louis Rabinovitch, merchant, Lily Berlin Rabinovitch, housewife, wife separate as to property of tire said Louis Rabinovitch, Hai ry Tobenstein, merchant, and Fay Rabinovitch Tobenstein, housewife, wife separate as to property of the said Harry Tobenstein, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of upholsterers, wood-makers, furniture makers and interior decorators, under the name of \"Carlton Upholstering Co.\", with a capital stock of $30,000 divided into 3,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney Gerreral this ninth day of January, 1951.* L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney Général.Coronet Textiles Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux décembre 1950, constituant en corporation: Norman Romer, industriel, Norman Genser, Sydney Phillips, avocats et Tessy Frankcl, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer, le commerce qui consiste à manufacturer et faire le négoce de produits textiles de toute nature et description, sous le nom de \"Coronet Textiles Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Fraser Sinclair & Company, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la 'Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf janvier 1951, constitutant en corporation : Shirley Greenshields Dixon, conseil en loi du Roi, John Fitzwilliam Stairs, John Brooke Claxton, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires comme courtiers d'assurances, et agir comme agents d'assurances, sujettes aux dispositions de la Loi des assurances de Québec et des règlements faits en vertu d'i-celle, sous le nom de \"Fraser Sinclair & Company, Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Coronet Textiles Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1950, incorporating: Norman Romer, industrialist, Norman Genser, Sydney Phillips, advocates, and Tessy Frankel secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in textiles of every nature and description, under the name of \"Coronet Textiles Ltd.\", with a capital stock of $40,000.dividod into 390 preferred shares of a par value of $100.each, and 1,000 common shares having a par value of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Fraser Sinclair & Company, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Apt, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing ojate the ninth day of January, 1951, incorporating: Shirley Green-shields Dixon, King's Counsel, John Fitzwilliam Stairs, John Brooke Claxton, adveotes, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of insurance brokers, and to act as insurance agents, subject to the provisions of the Quebec Insurance Act and the regulations made thereunder, under the name of \"Fraser Sinclair & Company, Inc.\", with a capital stock of $10,000.divided into 100 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Mc-ntreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, J 951.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General. 614 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 88, N° 7 Guignion Bros.Ltd.\u2022Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq janvier 1951, constituant en corporation: Percy John Guignion, quincailliers, Lewis Richard Guignion, quincaillier et Roland Ernest Horner, comptable, tous du village de Gaspé, district judiciaire de Gaspé, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quincaillerie dans toutes eu aucune de ses spécialités, sous le nom de \"Guignion Bros.Ltd.\", avec un capital de §60,000 divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au village de Gaspé, district judiciaire de Gaspé.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Guignion Bros.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1951, incorporating: Percy John Guignion, hardware merchant, Lewis Richard Guignion, hardware merchant, and Roland Ernest Horner, accountant, all of the Village of Gaspé, Judicial District of Gaspé, for the following purposes: To carry on in all or any of their branchcs.the businesses of hardware merchants, under the name of \"Guignion Bios.Ltd.\", with a capital stock of $60,000.divided into 300 common shares of $100.each, and 300 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at the Village of Gaspé, Judicial District of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1951, L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.International Lithographing Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre janvier 1951, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi du Roi, de Westmount, Theodore Herzl Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, Jean McFar-lane, dactylographe, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire tous actes concernant la manufacture, la fabrication, le commerce et l'industrie de la publicité particulière à la vente, des panneaux-réclames, étalages de toute sorte ou matéria-ux, photogravure, imprimerie, reliure et publication de journaux, sous le nom de \"International Lithographing Corporation\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté dir bureau du Procureur général, le quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Isaïe Boyer Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze janvier 1951, constituant en corporation: Maurice Fauteux, C.R., Marc-André Blain, avocats, et Luce Laferrière, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneur ou sous-entrepreneur dans la construction, sous le nom de \"Isaïe Boyer Limitée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le onze janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29363-o L.DÉSILETS.International Lithographing Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letteis patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1951, incorporating: Benjamin Robinson, advocate and King's Counsel, of Westmount, Theodore Hcrzl Shapiro, advocate, of the Town of Mount Royal, Jean McFarlane, typist, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To do all acts respecting the manufacture, fabrication, business and trade of point of sale advertising, sign-making, displays cf any kind or material photoengraving, printing, binding and publication of newspaper, under the name of \"International Lithographing Corporation\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Isaïe Boyer Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of January, 1951, incorporating: Maurice Fauteux, K.C., Marc-André Blain, advocates, and Luce Laferrière, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following puiposes: To act as building contractors or sub-contractors, under the name of \"Isaïe Boyer Limitée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1961, Vol.83, No.7 615 J.Accurso Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit décembre 1950, constituant en corporation: Gérard Corbeil, avocat, de Lon-gueuil, Léo pavignon, comptable, de Montréal et Jeanne DrOuin, secrétaire, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"J.Accurso Ltd.\", avec un capital de $200,000 divisé en 2,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.J.L.Audette et Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutennat-gouverncur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1951, constituant en corporation: Paul Audette, Commis, Patrick F.Toman, comptable, et Gérald Ally, avocat, tous de Farn-ham, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtel, sous le nom de \"J.L.Audette et Compagnie Limitée\", avec un capital de $75,000 divisé en 7,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Farnham, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463-0 L.DÉSILETS.La Salle Flooring and Insulation Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois janvier 1951, constituant en corporation: Régent Desjardins, entrepreneur, Rivière-des-Prairies, Jehan Perdriau, avocat et Françoise Caisse, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands d'enduits de planchers et de matériaux isolants, sous le nom de \"La Salle Flooring and Insulation Co.Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Le Club Sportif de Daveluyville Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'ar- J.Accurso Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1950, incorporating: Gérard Corbeil, advocate, of Longueuil, Léo Davignon, accountant, cf Montreal, and Jeanne Drouin, secretary, of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"J.Accurso Ltd.\" with a capital stock of $200,000.divided into 2,000 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December, 1950; L.DÉSILETS, 20463-o Deputy Attorney General.J.L.Audette et Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1951, incorporating: Paul Audette, clerk, Patrick F.Toman, accountant, and Gérard Ally, adovcate, all of Farnham, judicial district of Bedford, for the following purposes: To carry on the hotel business, under the name of \"J.L.Audette et Compagnie Limitée\", with a capital stock of S75.000 divided into 7,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Farnham, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463 Deputy Attorney General.La Salle Flooring and Insulation Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1951, incorporating: Regent Des-jardins, contractor, Rivière-des-Prairies, Jehan Perdriau, advocate, and Françoise Caisse, secretary, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business ôf manufacturers and dealers in floor coverings, and of insulators,' under the name of \"La Salle Flooring and Insulation Co.Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 common shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Le Club Sportif de Daveluyville Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 616 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Vome 88, N° 7 , ticle 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Ouellet, Hermann Fournier, Marius Ouel-lette, industriels, J.-A.Bruneau, comptable, Adrien Bédard, contre-maître, Philippe Smith, camionneur, Walter Gaudet, Jean-Paul Marcotte, Alexandre Beaumier, ouvriers, et Guy.Cantin, comptable, tous de Daveluyville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Former un Centre d'amusement, sous le nom de \"Le Club Sportif de Daveluyville Inc.\".Les pouvoirs accordés ne permettent pas les jeux à l'argent, les jeux de hasard, ni les jeux mixtes de hasard et d'habileté, tous ces jeux étant interdits par les présentes et n'autorisent pas non plus le club a demander, détenir ou exploiter une licence octroyée par la Commission des liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la coiporation peut posséder est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à Daveluyville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le douze janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463-0 L.DÉSILETS.276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of January, 1951, to incorporate as a corporation: without share capital: Gérard Ouellette, Hermann Foui nier, Marius Ouellette, industrialists, J.-A.Bruneau, accountant, Adrien Bédard, foreman, Philippe Smith, carter, Walter Gaudet, Jean Paul Marcotte, Alexandre Beaumier, workmen, and Guy Cantin, accountant, all of Daveluyville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To organize a recreational center, under the name of \"Le Club Sportif de Daveluyville Inc.\" The powers conferied do not permit gambling, games of chance, nor games of chance and skill mixed, the said games being hereby prohibited nor do they authorize the club to apply for, hold or operate a license granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to which the immovable property wliich the corporation may hold is to be limited is $5,000.The head office of the corporation will be at Daveluyville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463 Deputy Attorney General.L'Ermitage des Sapins Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du neuf janvier- 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Solange Perron, ménagère, de Vieilles Forges, Lucille Clément, ménagère, des Trois-Rivières, et Cécile Hamel, ménagère, de Mont-Carmel, toutes du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Fonder, établir et maintenir dans la province de Québec, des maisons de refuge, de repos et de pensions de toutes sortes, sous le nom de \"L'Ermitage des Sapins Inc.\", Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $40,000.Le siège social de la corporation sera à Vieilles Forges, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463-0 L.DÉSILETS.Les Immeubles Sauriol & Rose Inc.Sauriol & Rose Real Estate Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première parti^ de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze janvier 1951, constituant en corporation: François Sauriol, vendeur, Albert Rose, agent-vendeur, et Gérard-J.Bergeron, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme intermédiaires ou agents pour l'achat ou la vente de biens immeubles, de propriétés de toutes valeurs, sous le nom de \"Les L'Ermitage des Sapins Inc.Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the ninth day of January, 1951; to incorporate as a corporation without share capital: Solange Perron, housewife, of \"Vieilles Forges\", Lucille Clément, house-wife, of Trois-Rivières, and Cécile Hamel, housewife, of Mont-Carmel, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes : To found, establish and maintain, in the Province of Quebec, houses cf refuge, rest homes and board-houses of all kinds, under the name of \"L'Ermitage des Sapins Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $40,000.The head office of the Corporation will be at \"Vieilles Forges\", judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463 Deputy Attorney General.Les Immeubles Sauriol & Rose Inc.Sauriol & Rose Real Estate Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of January, 1951, incorporating: François Sua-riol, salesman, Albert, Rose, sales agent, and Gérard J.Bergeron, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To \"act as intermediaries or agents for the purchase 6r sale of real estate, properties of any value whatsoever, under the name of \"Les Im- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 617 Immeubles Sauriol & Rose In .\" \u2014 \"Sauriol & Rose-Real Estate Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 1100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1951.?L'Assistant-procureur général, 29463-0 L.DÉSILETS.Les Produits Laitiers Marieville Ltée Maricville Dairy Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit janvier 1951, constituant en corporation: Jos.Cohen, Ezra Leithman, avocats, et Dorothy Singer, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et négocier et faire le commerce de toutes sortes et descriptions de produits laitiers, agricoles et maraîchers, sous le nom de \"Les Produits Laitiers Marieville Ltée\"\u2014\"Marieville Dairy Products Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Marie-ville, district judiciaire de St-Hyacinthe.Dat' du bureau du Procureur général, le huit janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Ludger Lepage & Fils Limitée Avis est donné qu!en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize janvier 1951, constituant en corporation: Jos-Alfred Dion, avocat, Léonce Lévesque, notaire, et Françoise Hamel, sténographe, tous trois de Roberval, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises, meubles en bois ou en métal, accessoires électriques, quincaillerie, ferronnerie, sous le nom de \"Ludger Lepage & Fils Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le treize janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463-0 L.DÉSILETS.Main Hebrew Delicatessen Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente décembre 1950, constituant en corporation: Jacques Lotey, Henryk Kalinowicz, marchands et Gregory Chprlap, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: meubles Sauriol & Rose Inc.\" \u2014 \"Sauriol & Rose Real Estate Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 1100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463 Deputy Attorney General.Les Produits Laitiers Marieville Ltée Marieville Dairy Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued -by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1951, incorporating: Jos.Cohen, Ezra Leithman, advocates, and Dorothy Singer, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in and with all kinds and descriptions of dairy, farm and garden produce, under the name of \"Les Produits Laitiers Marieville Ltée\"\u2014Marieville Dairy Products Lted.\", with -a capital stock of $40,000.divided into 150 common shares of a par value of $100.each and 250 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Marieville, in the Judicial District of St.Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of January,\"195l.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Ludger Lepage & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of January, 1951, incorporating: Jos.Alfred Dion, advocate, Léonce Lévesque, notary, and Françoise Hamel, stenographer, all three of Roberval, judicial district of Roberval, for the following purposes: To deal in merchandise, wood or metal furniture, electrical appliances, hardware, ironware, under the name of \"Ludger Lepage & Fils Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Félicien, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1951.L.DÊSLLETS, 29463 Deputy Attorney General.Main Hebrew Delicatessen Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1950, incorporating: Jacques Lotey, Henryk Kalinowicz, merchants, and Gregory Charlap, advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: 618 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 88, N° 7 Exercer le commerce de friandises, viandes, épicieries, légumes, fruits et lignes connexes et aussi le commerce d'un restaurant et comptoir-lunch, sous le nom de \"Main Hebrew Delicatessen Inc.\", avec un capital de $40,00.0 divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bin eau du Procureur général, le trente décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.To carry on the business of delicatessens, meat products, groceries, vegetables, fruits and associated lines, and the business of restaurant and lunch counter, under the name of \"Main Hebrefy Delicatessen Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.This head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December 1950.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Noranda Recreation Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Richard Valentine Porritt, gé.vant, Clayton Earle Anderson, assistant-gérant, Sidney Day Cookc.comp-table en chef de mine, Cecil John Drummond, secretaire du gérant, et Gordon Griffith, comptable de mine, tous de Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants : Permettre, organiser et fournir des facilités en vue de l'exploitation de clubs et autres associations dans des buts sportifs, récréatifs et sociaux pour le bien-être de la localité, sous le nom de \"Noranda Recreation Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 8800.000.Le siège social de la coi poration sera en la cité de Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Noranda Recreation Association Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1951, incorporating without share capital: Richard Valentine Porritt, manager, Clayton Earle Anderson, assistant manager, Sidney Day Cooke, chief mine accountant, Cecil John Drummond, secretary to manager and Gordon Griffith, mine accountant, all of Noranda, Judicial District of Rouyn-Noranda, for the following purposes: To permit, organize and provide facilities for operation of clubs and other associations for sports and recreational and social purposes for the welfare cf the community, under the name of \"Noranda Recreation Association\".The amount to which the value of the immoveable property wKich the corporation mav hold is to l>e limited is $800,000; The head office of the Corporation will be at the City of Noranda, in the Judicial District of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Oriental Art Studios Ltd.' Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq janvier 1951, constituant en corporation: Milton Cohen, manufacturier, Harry Cohen, vendeur et Moe Edward Cohen, gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de vêtements et habits de toute description, sous le nom de \"Oriental Art Studios Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2027 rue St-Timothée, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Park Extension Amateur Athletic-Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf janvier 1951, consti- Oriental Art Studios Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1951, incorporating: Milton Cohen, manufacturer, Harry Cohen, salesman, and Moe Edward Cohen, manager, all Of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers in garments and clothing of every description, under the name of \"Oriental Art Studios Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 preferred shares of $100.each, and 1,000 common shares of $10.each.The head office of the Company will be at 2027 St.Timothée Street, Montreeal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Park Extension Amateur Athletic Association Notice is hereby given that under the provisions of Part ni of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1981, incor- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.82, No.7 619 tuant en corporation sans capital-actions: Charles Silverman, gérant d'usine, Jack Maggiorino, cordonnier, Marcel Poirier, gérant de ventes:, J.Borden Rollins, gérant de ventes, John J.O'Hara, vendeur, Gardner Moore, technicien, Henriot Laforcst, vendeur, Alexander J.Smiley, marchand de radio et Fred Haward, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir, encourager et promouvoir tous genres d'athlétisme, les sports et la culture, le développement et le vien-être physique, mental et moral, sous le nom de \"Park Extension Amateur Athletic Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Phil-Mo Ice Cream Cie Ltée Phil-Mo Ice Cream Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moiisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze janvier 1951, constituant en corporation: André Nadeau,' avocat, Claire Pigeon et Lyse Mignault, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme commerçants et producteurs de produits laitiers, agricoles et maraîchers de toutes sortes, sous le nom de \"Phil-Mo Ice Cream Cie Ltée\" \u2014 \"Phil-Mo Ice Cream Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune, et en 100 actions privilégiées de Si 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, djstrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1951.L'Assistant-procureur général, -29463-o 1 L.DÉSILETS.Radio & Television Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept décembre 1950, constituant en cerporation: Invin A.Frankel, avocat, Louis M.Benjamin, avocat et Sadie Gersovitz, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général qui consiste à fournir des divertissements et des représentations au public et exercer le commerce qui consiste à organiser des représentations théâtrales et radiophoniques, et agir comme agents de théâtres et'ou de publicité, sous le nom de \"Radio & Television Sales Inc.\".Le capital de la compagnie est divisé en 200 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $1,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.porating without share capital: Charles Silverman, Plant Manager, Jack Maggiorino, Shoe Maker, Marcel Poirier, Sales manager, J.Borden Rollins, sales manager, John J.O'Hara, Salesman, Gardner Moore, Technician Henriot La-forest, Salesman.Alexander J.Smiley, Radio Merchant, and Fred Howard, clerk, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To establish, encourage and promote all forms of athletics, sports and physical, mental and moral culture, development and well-being under the name of \"Park Extension Amateur Athletic Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited is $50,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29403-o Deputy Attorney General.Phil-Mo Ice Cream Cie Ltée Phil-Mo Ice Cream Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, cfrapter 276.R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of January, 1951, incorporating: André Nadeau, advocate, Claire Pigeon and Lyse Mignault, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as dealers in and producers of dairy, farm and garden products of all kinds, under the name of \"Phil-Mo Ice Cream Cie Ltée\" \u2014 \"Phil-Mo Ice Cream Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 common shares of S100 each, and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of- the Attorney General, this eleventh day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463 Deputy Attorney General.Radio & Television Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of December, 1950, incorporating: Invin A.Frankel, advocate, Louis M.Benjamin, advocate, and Sadie Gersovitz, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of furnishing amusement and entertainment to the public and to carry on the business of organizing theatrical and radio performances and.to act as theatrical and'or advertising agents, under- the name of \"Radio & Television Sales Inc.\", The capital stock of the company is divided into 200 common shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $1,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of December, 1950.L.DÉSILETS.29464-0 Deputy Attorney General. 620 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 Rembrandt Art Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq janvier 1951, constituant en corporation: Milton Cohen, manu facturier, Harry Cohen, vendeur et Moe Edward Cohen, gérant, tous des cité et district judiciaire^ de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général comme manufacturiers et marchands de vêtements de toute description, sous le nom de \"Rembrandt Art Corporation\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées de $100 chacune et en 1,000 actions ordniares de $10 chacune.Le siège social de ' la compagnie sera à 2027 rue St-Timothée, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Rembrandt Art Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1951, incorporating: Milton Cohen, manufacturer, Harry Cohen salesman, and Moe Edward Cohen, manager, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers generally in garments of every description, under the name of \"Rembrandt Art Corporation\", with a capital stock of $40,000.divided into 300 preferred shares of $100.each, and 1,000 common shares of $10.each.The head office of the Company will be at 2027 St.Timothée Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Romertex Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi de \u2022¦ compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux décembre 1950, constituant en corporation: Norman Romer, industriel, Norman Genser, Sydney Phillips, avocats, et Tessy Frankel, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et négocier des produits textiles de toute nature et description, sous le nom de \"Romertex Corporation\", avec un capital de $75,000 divisé en\" 740 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 action ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1950.** L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Romertex Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1950, incorporating: Norman Romer, industrialist, Norman Genser, Sydney Phillips, advocates, and Tessy Frankcl, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in textiles of every nature and description, under the name of \"Romertex Corporation\", with a capital stock of $75,000.divided into 740 preferred shares having a par value of $100.each, and 1,000 common shares having a par value of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.R.Pasquini Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accerdé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois janvier 1951, constituant en corporation: Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, Léo Davi-*gnon, comptable, de MontréaLet Jeanne Drouin, secrétaire, d'Outremont, tous du district judi-cicaire de Montréal, pour les objets suivants: Exetcer le commerce comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"R.Pasquini Co.Ltd.\"., avec un capital de $10*000 divisé en 10,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1951.L'Assistant-procureur généra], 29463 L.DÉSILETS.R.Pasquini Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1951, incorporating: Gérard Corbeil, advocate, of Longueuil, Léo Davignon,< accountant, of Montreal, and Jeanne Drouin, secretary, of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"R.Pasquini Co.Ltd.\", with a capital stock of $10,000.divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Shoe Bazaar Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Shoe Bazaar Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, .Quebec, February 17th, 1961, Vcl.83, No.7 621 province de Québec, des lettres patentes en date du quatre janvier 1951, constituant en corporation: Hyman Michaels, marchand, Barney Michaels, vendeur et Samuel Stein, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de vêtements de toute description, sous le nom de \"Shoe Bazaar Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Snowdon Investments Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre janvier 1951, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, C.R., Manuel Shacter, avocats, Anne Ross et Thelma Bean, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaires de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Snowdon Investments Corp.\", avec un capital de $100,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.St.Catherine 5c to $1.00 Store Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept décembre 1950, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, C.R., Manuel Shacter, avocats, Thelma Bean et Anne Ross, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général comme marchands de vêtements, marchandises sèches, bottes et chaussures et autres marchandises générales, sous le nom de \"St.Catherine 5c.to $1.00 Store Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 2C0 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Super Steel & Metal Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq janvier 1951, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi du Roi, ince of Quebec, bearing date tlie fourth day of January, 1951, incorporating: Hyman Michaels, merchant, Barney Michaels, salesman,, and Samuel Stein, advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers in wearing apparel of every description, under the name of \"Shoe Bazaar Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 250 common shares of $100.each, and 150 prefeired shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tin's fourth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Snowdon Investments Corp.Notice is hereby-given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1951, incorporating: Louis H.Rohrlick, K.C., Manuel Shacter, advocates, Anne Ross and Thelma Bean, secretaries, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Snowdon Investments Corp.\", with a capital stock of $100,000 divided into 200 common shares of the par value of $100 each, and 800 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.St.Catherine 5c to $1.00 Store Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of December, 1950, incorporating: Louis H.Rohrlick, K.C., Manuel Shacter, advocates, Thelma Bean and Anne Ross, secretaries, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers generally in clothing, dry goods, boots and shoes, and other general merchandise, under the name of \"St.Catherine 5c.to $1.00 Store Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of the par value of $100.each, and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-seventh day of December 1950.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Super Steel & Metal Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies, Act letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1951, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Jean McFarlane, typist 622 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 Jean McFarlane, dactylographe, tous deux de la cité de Montréal, Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Westmount, Theodore Hcrzl Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer les métiers et le commerce comme manufacturiers de fer, fabricants d'acier, convertisseurs d'acier, fondeurs, lamineurs de métaux en feuilles et de rails, fabricants de plaques en étain, sous le nom de \"Super Steel & Mctaj Co.\", avec capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Tank Truck Transportation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, des lettres patentes en date du cinq janvier 1951, constituant en corporation: Ernest Kilton Barnard, Llewellyn T.Barnard et Kilton (iile Barnard, tous d'Oxford Mills, province d'Ontario, pour les objets suivants: Exercer le commerce de transport, sous le nom de \"Tank Truck Transportation Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.The Campbell's Bay Curling Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre janvier 1951, constituant en corporation: Douglas Campbell, mineur, Rev.L.Êmard, ministre du culte, Clifton Corrigan, gérant de laiterie, J.Denzil Moodie, marchand, Edward C.Lawn, marchand, Hillis Smith, voiturier, tous de Campbell's Bay et Robert Carter, gérant de mine, de l'Ile Grand Calumet, tous du district judiciaire de Pontiac, pour les objets suivants: Exploiter un club de curling, sous le nom de \"The Campbell's Bay Curling.Club Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 400 actions de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera au village de Campbell's Bay, district judiciaire de Pontiac.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur both of the City of Montreal, Benjamin Robinson, advocate and King's Counsel, of the city of Westmount, Theodore- Herzl Shapiro, advocate, of the Town of Mount-Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trades and business of iron manufacturers, steel makers, steel converters, smelters, sheet metal and rail rollers, tin plate makers, under the name of \"Super Steel & Metal Co.\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each, and 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of Januarv, 1951.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Tank Truck Transportation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1951, incorporating: Ernest Kilton Barnard, Llewellyn T.Barnard and Kilton Gile Barnard, all of Oxford Mills, Province of Ontario, for the following purposes: To carry on the transportation business, under the name of \"Tank Truck Transportation Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of Januarv, 1951.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.The Campbell's Bay Curling Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1951, incorporating: Douglas Campbell, miner, Rev.L.Emard, clergyman, Clifton Corrigan, dairy manager, J.Denzil Moodie, merchant, Edward C.Lawn, merchant, Hillis Smith, carrier, all of Capmbell's Bay, and Robert Carter, mine manager, of Grand Calumet Island, all in the Judicial District of Pontiac, for the following purposes: To carry on curling operations, under the name of 'The Campbell's Bay Curling Club Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 400 shares of $25.each.The head office of the Company will be at the Village of Campbell's Bay, in the Judicial District of Pontiac.Dated at the office of the Attorney General this fourth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29463-o Deputy Attorney General.Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieute- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1961, Vol.83, No.7 623 de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit décembre 1950, constituant en corporation: Frank J.Dolan, comptable, J.Austin Murphy, C.R., procureur, Lottie Pachal, dactylographe, George Arthur Ovenden, comptable, et Denyse Paret, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Wce-don Pyrite & Copper Corporation Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de 33,000,000 divisé en 3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être paye à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29463 L.DÉSILETS.nant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1950, incorporating: Frank J.Dolan, accountant, J.-Austin Murphy, K.C., barrister, Lottie Pachal, typist, George Arthur Ovenden, accountant, and Denyse Paret, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Weedon Pyrite.& Copper Corporation Limited (No Personal Liability)\", with a capital stock of 83,000,000 divided into 3,000,000 shares of SI.each.The shareholders of the company shall incur no personal liability in excess of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will bey,, at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29463-0 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Allied Flock and Felt Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 janvier 1951, à la compagnie \"Canadian Flock and Felt Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 novembre 1950, changeant son nom en celui de \"Allied Flock and Felt Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 19 janvier 1951; L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Supplementary Letters Patent Allied Flock and Felt Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Canadian Flock and Felt Inc.\", incorporated by letters patent dated Noveml>er 28th, 1950, changing its name to that of \"Allied Flock and Felt Inc., Dated at the office of the Attorney General, this 19th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Bernard Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 31 janvier 1951, à la compagnie \"Bernard Construction Ltée\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le 31 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464-o L.DÉSILETS.Bourquc Electrique, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 janvier 1951, à la compagnie \"Bourque Electrique, Limitée\", ratifiant son règlement N° 3 augmentant son capital de Bernard Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the thirty-first day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Bernard Construction Ltée\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of Januarv, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.Bourque Electrique, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, seupplementary letters patent bearing date the twenty-third day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Bourque Electrique.Limitée\", ratifying its By-law No.3, increasing its capital stock from 624 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 82, N° 7 $3,000 à $78,000 par la création de 15,000 actions privilégiées de $5 chacune et comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 23 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.Can tin Sales Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 23 janvier 1951, à la compagnie \"Cantin Sales Agencies Ltd.\", ratifiant son règlement spécial \"I\", réduisant son capital autorisé par l'annulation de 900 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune, et fixant le montant du capital avec lequel la compagnie exercera son commerce à pas moins que $500.Daté du bureau du Procureur général, le 23 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Deckelbaum Bros.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres supplémentaires en date du 11 janvier 1951, à la compagnie \"Deckelbaum Bros.Ltd.\", ratifiant son règlement N° 30, augmentant son capital de $20,000 à $350,000 par la création de: o) 150 actions catégorie \"A\" additionnelles de $100 chacune; b) 250 actions catégorie \"B\" additionnelles de $100 chacune comportant les privilèges et restrictions mentionnées audit règlement; c) 2,900 nouvelles actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 11 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Halickman Bros.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 23 janvier 1951, à la compagnie \"Halickman Bros.Ltd.\", ratifiant son règlement No.25, augmentant son capital autorisé de $100,000 à $250,000 par la création de 500 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 23 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.$3,000 to $78,000, by the creation of 15,000 preferred shares of $5 each, and subject to the rights, restrictions and privileges enumerated inthesaid By-Law.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third d*y of January, 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Cantin Sales Agencies Ltd.Notice is hereby given tliat under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Cantin Sales Agencies Ltd.\", ratifying its Special By-Law \"I\" reducing its authorized capital stock by the cancellation of 900 common shares without nominal or par value and 1,000 preferred shares of $100 each, and fixing the amount of capital with which the company will carry on business at not less than $500.Dated at the office of the Attorney General, tins 23rd day of January, 1951.\u2022 L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Deckelbaum Bros.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Deckelbaum Bros.Ltd.\", ratifying its By-Law No.30 increasing its capital stock from $20,000 to $350,000 by the creation of : a) 150 additional Class \"A\" shares of $100 each; b) 250 additional Class \"B\" shares of $100 each carrying the privileges and restrictions mentioned in such by-law; c) 2,900 new preferred shares of $100 each to be subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at .the office of the Attorney General, this 11th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o.Deputy Attorney General.Halickman Bros.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Halickman Bros.Ltd.\", ratifying its By-Law No.25 increasing its authorized capital stock from $100,-000 to $250,000 by the creation of 500 additional common shares of $100 each, and 1,000 additional preferred shares of $100 each, subject to the rights restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 23rd day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Houde, Laroche & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplé- Houde, Laroche & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-fifth day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Go- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 625 mentaires, en date du 25 janvier 1951, à la compagnie \"Houde, Laroche & Cie Ltée\", ratifiant son règlement spécial N° 12, subdivisant, créant et émettant 500 actions ordinaires de $100 chacune du capital-actions autorisé sous forme de 5,000 actions privilégiées de $10 chacune comportant les droits, restrictions et privilèges énu-mérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 25 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.La Cie Métallique Victoria, Limitée The Victoria Metallic Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 29 décembre 1950, à la compagnie \"La Cie Métallique Victoria, Limitée\" \u2014\"The Victoria Metallic Co.Limited\", ratifiant son règlement N° 3: a) subdivisant ses 195 actions communes de $100 chacune en 1950 actions communes de $10 chacune; /;) augmentant le capital-actions autorisé de ladite com-pag lie de $19,500 à $99,500, par la création de 800 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges, énumérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 29 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.Laviolctte Chemicals Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 janvier 1951, à la compagnie \"St.Maurice Chemicals Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 novembre 1950, changeant son nom en celui de \"Laviolette Chemicals Co.Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le 30 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.Leisure Wear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 4 janvier 1951, à la compagnie \"Leisure Wear Inc.\", ratifiant son règlement \"B\", augmentant son capital autorisé de $20,000 à $80,000 par la création de 100 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune et de 500 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 4 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.vernor of the Province of Quebec, to the company \"Houde, Laroche & Cie Ltée\".ratifying its special by-law No.12, subdividing, creating and issuing 500 common shares of $100 each of the authorized capital stock as 5,000 preferred shares of $10 each subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.La Cie Métallique Victoria, Limitée The Victoria Metallic Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Supplementary letters patent, bearing date the twenty-ninth day of December, 1950, were issued by the L'eu-tcnant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"La Cie Métallique Victoria, Limitée\"\u2014\"The Victoria Metallic Co.Limited\", ratifying its by-law No.3 a) subdividing its 195 common shares of $100 each into 1950 common shares of $10 each; b) increasing the authorized capital stock of the said company from $19,500 to $99,590 by the creation of 800 preferred shares of $100 each, carrying the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.Laviolette Chemicals Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the thirtieth day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"St.Maurice Chemicals Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 9th day of November, 1950, changing its name into that of \"Laviolette Chemical Co.Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.Leisure Wear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 4th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Leisure Wear Inc.\", ratifying its By-law \"B\" increasing its authorized capital stock from $20,000 to $80,000 by the creation of 100 additional common shares of $100 each, and 500 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 4th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Leo.Perrault Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes srrp- Leo.Perrault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of Jan-nuary, 1951, were issued by the Lieutenant- 626 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 plémentaires en date du 31 janvier 1951, à la compagnie \"Léo.Perrault Limitée\", ratifiant son règlement spécial \"A\", augmentant son capital autorisé de $99,000 à $399,000 par la création de 3,000 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 31 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Les Huiles Penco Limitée Penco Oil Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 janvier 1951, à- la compagnie \"Les Huiles Penco Limitée\"\u2014\"Penco Oil Limited\", ratifiant son règlement No.VI portant son capital-actions de $49,900 à $200,000 par la création de 395 actions ordinaires de $100 chacune et de 22,120 actions privilégiées de $5 chacune, sujettes aux mêmes droits et restrictions que celles créées le 27 décembre 1950.Daté du bureau du Procureur général, le 26 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464-o L.DÉSILETS.Les Meubles de St-Barthélémi, Ltée St.Barthélémy Furniture Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 16 janvier 1951, à la compagnie \"Les Meubles de St-Barthélémy, Ltée\" \u2014 \"St.Barthélémy Furniture Ltd.\", ratifiant un règlement augmentant son capital-actions de $40,000 à $75,000 par la création de 350 actions ordinaires additionnelles de $100.Daté du bureau du Procureur général le 16 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.Letendre & Frères Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 janvier 1951, à la compagnie \"Letendre & Frères Limitée\", ratifiant: 1°, un règlement modifiant les privilèges attachés à ses actions privilégiées; 2°) un règlement divisant les actions privilégiées de ladite compagnie en classe \"A\" et en classe \"B\".Daté du bureau du Procureur général le 17 janvier 1951'.L'Assistant-procureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.Governor of the Province of Quebec, to the company \"Léo.Perreault Limitée\", ratifying its Special By-law \"A\", increasing its authorized capital stock from $99,000 to $399,000 by the creation of 3,000 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 31st day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Les Huiles Penco Limitée Penco Oil Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-sixth day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Huiles Penco Limitée\"\u2014\"Penco Oil Limited\", ratifying its by-law No.VI increasing its capital stock from $49,900 to $200,-000 by the creation of 395 common shares of $100 each and 22,120 preferred shares of $5 each, subject to the same rights and restrictions as those created on the twenty-seventh of December, 1950.Dated at the effice of the Attorney General, tin's twenty-sixth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.Les Meubles de St-Barthélémi, Ltée St.Barthélémy Furniture Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the sixteenth day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Meubles de St-Barthélémy, Ltée\" \u2014 St.Barthélémy Furniture Ltd.\", ratifying a By-law increasing its capital stock from $40,000 to $75,000 by the creation of 350 additional common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.Letendre & Frères Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the seventeenth day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Letendre & Frères Limitée\", ratifying: 1.a Bylaw amending the privileges attaching to its preferred shares; 2.a By-law dividing the preferred shares of the said company into Class \"A\" and Class \"B\" shares.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.Maurice Dress Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 janvier 1951, à la compagnie \"Maurice Dress Company Ltd.\", ratifiant son règlement N° 5, augmentant son capital de $98,000 à $150,000 par la création de 520 actions privilégiées catégorie \"B\" Maurice Dress Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Maurice Dress Company Ltd.\", ratifying its By-law No.5 increasing its capital stock from $98,000 to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, ~Î961, Vol.88, No.7 627 de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 24 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DESILETS.M.Berger & Sons Limited C Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 janvier 1951, à la compagnie \"M.Berger & Sons Limited\", ratifiant son règlement N° 25, augmentant son capital de $20,000 à $70,000 par la création de 250 actions ordinaires additionnelles de $100 cliacune et de 250 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 24 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, , 29464 L.DÉSILETS.McGuaig Bros.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettrse patentes, supplémentaires en date du 24 janvier 1951, à la compagnie \"McCuaig Bros.Inc.\", ratifiant son règlement spécial \"D\", réduisant son capital de $210,-000 à $176,600 par l'annulation de 3,340 actions privilégiées remboursées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 24 janvier 1951.L'Assistant-procureur rénéral, 29464 L.DÉSILETS.Metallurg (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 22 janvier 1951, à la compagnie \"Silyercrown (Canada) Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 janvier 1948, changeant son nom en celui de \"Metallurg (Canada) Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 22 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Sterling Woollens & Silks Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 janvier 1951, à la com-f pagnie \"Sterling Woollens & Silks Co.Ltd.\", ratifiant son rèelement \"C\", augmentant son capital de $99,000 à $449,000 par la création de 3,500 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 24 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.$150,000 by the creation of 520 class \"B\" preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.M.Berger & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"M.Berger & Sons Limited\", ratifying its By-Law No.25 increasing its capital stock from $20,000 to $70,000 by the creation of 250 additional common shares of $100 each and 250 preferred shares of $100 each .subject to the provileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.McGuaig Bros.Inc.Notice is hereby given that under Part I ofjthe Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"McCuaig Bros.Inc.\", ratifying its Special By-law \"D\", reducing its capital stock from $210,000 to $176,600 by the cancellation of 3,340 redeemed preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Metallurg (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent,* bearing date the 22nd day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Silvercrown (Canada) Limited\", incorporated by letters patent January 30th.1948, changing its name to that of \"Metallurg (Canada) Ltd\".Dated at the office of the Attorney General, this 22nd day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Sterling Woollens & Silks Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Sterling Woollens & Silks Co.Ltd.\", ratifying its By-Law \"C\" increasing its capital stock from $99,000 to $449,000 by the creation of 3,500 additional preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General. 628 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, Nc 7 The W.Howick Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite L*, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 janvier 1951, à la compagnie \"The W.Howick Mfg.Co.Ltd.\", ratifiant son règlement N° 21, augmentant son capital autorisé de $49,000 à $149,-000 par la création de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune ,sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Proerreur général, le 18 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.The W.Howick Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"The W.Howick Mfg, Co.Ltd.\", ratifying its By-law No.21 increasing its authorized capital stock from $49,000 to $149,000 by the creation of 1000 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 18th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Tymeley Frocks Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 25 janvier 1951, à la compagnie \"Tymeley Frocks Inc.\", ratifiant: 1° son règlement N° 24, augmentant le nombre de ses directeurs de 3 à 4; 2 son règlement N° 25, subdivisant 150 actions ordinaires de $100 chacune en 15.003 actions ordinaires de $1 chacune et convertissant lesdites 15,000 actions ordinaires de $1 en 15,000 actions privilégiées de $1 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement; 3° son règlement N° 26, augmentant son capital de $20,000 à $30,000 par la création de 10,000 actions privilégiés additionnelles de $1 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 25 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.United Amusement Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moriss?t, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 20 janvier 1951, à la compagnie \"United Amusement Corporation Limited\", ratifiant son règlement N° 67A subdivisant ses 100,000 actions sans valeur nominale ou au pair en 400,000 actions sans valeur nominale ou au pair et fixant à $2,000,000 le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations.Daté du bureau du Procureur général, le 20 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Z.Lavigueur Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 janvier 1951, à la compagnie, \"Z.Lavigueur Limitée\", ratifiant son règlement N° 29 augmentant son capital-actions Tymeley Frocks Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Tymeley Frocks Inc.\", ratifying: 1° its By-law No.24 increasing the number of its directors from 3 to 4; 2.its By-law No.25 subdividing 150 common shares of $100 each into 15,000 common shares of $1 each and converting the said 15,000 common shares of $1 into 15,000 preferred shares of $1 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law; 3.its by-law No.26 increasing its capital stock from $20,000 to $30,000 by the creation of 10,000 additional preferred shares of $1 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 25th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.United Amusement Corporation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by 'Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"United Amusement corporation Limited\", ratifying its By-law No.67A subdividing its 100,000 shares without nominal or par value into 400,000 shares without nominal or par value and fixing at $2,000,000 the amouut with which the company will continue its opérations.Dated at the office of the Attorney General, this 20th day of January, 1951.L.DÉSILETS.29464-0 Deputy Attorney General.Z.Lavigueur Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the twenty-third day of January 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Prccinve of Quebec, to the company \"Z.Lavigueur Limitée\" ratifying its By-law No.29, increasing its authorized capital stock QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1961, Vol.83, No.7 629 autorisé de $40,000 à $90,000 par la création de 500 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 23 janvier 1951.L'Assistant-piocureur général, 29464-0 L.DÉSILETS.A.D.McGibbon & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 16 décembre 1950 à la compagnie \"A.D.McGibbon & Sons Limited\", ratifiant: 1° son règlement spécial \"A\" désignant comme \"actions ordinaires\" les 450 actions de $100 de son capital-actions; 2° son règlement sDécial \"B\" augmentant ledit capital de $15.000 à $145,000 par la création de 20,000 nouvelles actions privilégiées de $5 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 16 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.A.Pcsner & Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 décembre 1950, à la compagnie \"A.Pesner & Co.Inc.\", ratifiant son règlement N° 24, augmentant son capital autorisé par la création de 2,000 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 18 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Arden Fur Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 20 décembre 1950, à la compagnie \"Arden Fur Corp.\", ratifiant son règlement N° 50, augmentant son capital de $20,000 à $120,000 par la création de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit' règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 20 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.from $40,000 to $90,000 by the creation of 500 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges, enumerated in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this twenty third day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464 Deputy Attorney General.A.D.McGibbon & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"A.D.McGibbon & Sons Limited\", ratifying: 1.its Special By-law \"A\" designating as \"common shares\" the 450 shares of $100 of its capital stock: 2.its Special By-law \"B\" increasing the said capital stock from $45,000 to $145,000 by the creation of 20,000 new preferred shares of $5 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 16th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.A.Pesncr & Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"A.Pesner & Co.Inc.\", ratifying its By-Law No.24 increasing its authorized capital stock by the creation of 2,000 additional preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 18th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Arden Fur Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Arden Fur Corp.\", ratifying its By-Law- No.50 increasing its capital stock from $20,000 to $120,000 by the creation of 1,000 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 20th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Canadian Cotton & Wool Waste Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 décembre 1950, à la compagnie \"Canadian Cotton & Wool Waste Co.Limited\", ratifiant son règlement N° 26, augmentant son capital de $49,000 à $149,000 par la création de 1,000 actions privilégiées de Canadian Cotton & Wool Waste Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of December, 1950.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Canadian Cotton & Wool Waste Co.Limited\", ratifying its By-Law No.26 increasing its capital stock from $49,000 to $149,000 by the creation of 1,000 preferred shares of $100 each, 630 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1961, Tome 83, N° 7 $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 18 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 18th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Canadian Plywoods Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été M cordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 26 janvier 1951, à la compagnie \"Canadian Plywoods Limited\", ratifiant: 1° une résolution étendant les pouvoirs de ladite compagnie; 2° son règlement N° A-3 augmentant son capital par la création de 2,000 nouvelles actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement, et fixant à $25,000 le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations.Daté du bureau du Procureur général, le 26 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Canadian Plywoods Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Canadian Plywoods Limited\", ratifying: 1.a resolution extending the powers of the said company; 2.its By-law No.A-3 incieasing its capital stock by the creation of 2,000 new preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said bylaw, and fixing at $25,000 the amount with which the company will continue its operations.Dated at the office of the Attorney General, this 26th day of January.1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Consolidated Quebec Gold Mining & Metals Corporation (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 31 janvier 1951, à la compagnie \"Quebec Gold Mining Corporation\" (Libre de responsabilité personnelle), constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec par lettres patentes en date du 6 février 1933, ratifiant 1° son règlement N° 43, modifiant les règlements généraux de ladite compagnie et modifiant ses pouvoirs de la manière indiquée dans ce règlement; 2° son règlement N°'45; a) convertissant 1,000,000 d'actions ordinaires non émises de $1 chacune en 1,000.000 d'actions privilégiées de $1 chacune, sujettes aux droits, privilèges et restrictions mentionnés audit règlement N° 45; 6) consolidant les 3.000,000 d'acMons ordinaires restantes de $1 chacune en 1,200,000 actions ordinaires de $2.50 oha'une; 3° son règlement N° 46, changeant le nom de ladite compagnie de \"Quebec Gold Mining Corporation\" (Libre de responsabilité pers^nneMei en celui de \"Consolidated Quebec Gold Mining & Metals Corporation\" (Libre de responsabilité personnelle).Daf.é du bureau du Procureur général, le 31 janvier 1951.L'Assistant-procureur généra', 29464 L.DÉSILETS.Harrison Transport & Equipment Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 décembre 1950, à la compagnie \"Star Transport & Equipment Company, Inc.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 a vil 1948, changeant son nom en celui de \"Harrison Transport & Equipment Company Inc.\" Consolidated Quebec Gold Mining«& Metals Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the \"Quebec Gold Mining Corporation (No Personal Liability) a company incorporated under the Quebec Mining Companies' Act by letters patent dated February 6th, 1933, ratifying: 1.its By law No.43 modify ing the general by-laws of the said company and modifying the poweis thereof in the manner set forth in such by-law; 2.its By-law No.45: a) converting 1,000,000 of the unissued common shares of $1 each into 1,000,000 preferred shares of $1 each subject to the rights, privileges and restrictions mentioned in the said By-law No.45; b) consolidating the remaining of 3,000,000 common shares cf $1 each into 1,200,000 common shares of $2.50 each; 3.its By-law No.46 changing the name of the said company from Quebec Gold Mining Corporation (No Personal Liability) to \"Consolidated Quebec Gold Mining & Metals Corporation\" (No Personal Liability).Dated at the Office of the Attorney General, this 31st day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Harrison Transport & Equipment Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Star Transport & Equipment Company, Inc.\" incorporated by letters patent dated April 22nd, 1948, changing its name to that of \"Harrison Tiansport & Equipment Company Inc.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 631 Daté du bureau du Procureur général, le 18 Dated at the office of the Attorney General, décembre 1950.* this 18th day of December, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29464 L.DÉSILETS.29464-o Deputy Attorney General.Herman Bros.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 20 décembre 1950, à la compagnie \"Herman Bros.Limited\", ratifiant son règlement N° 24, augmentant son capital autorisé de $20,000 à $60,000 par la création de 400 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 20 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Herman Bros.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Herman Bros.Limited\", ratifying its By-Law No.24 increasing its authorized capital stock from $20,000 to $60,000 by the creation of 400 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 20th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.International Laces Incorporated Avis est donné qir'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 14 décembre 1950, à la compagnie \"International Laces Incorporated\", ratifiant: 1° son règlement N° 23, diminuant son carital de $20,000 à $14,000 par l'annulation de 600 actions ordinaires de $10 chacune; 2° son règlement N° 24, augmentant son capital de $14,000 à $164,000 par la création de 1,500 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général.He 14 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Overseas Textiles Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 14 décembre 1950, à la compagnie \"Overseas Textiles Ltd.\", ratifiant son règlement N° 4, augmentant son capital autorisé de $49,000 à $249,000 par la création de 2,000 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 14 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Nat Gordon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 janvier 1951, à la compagnie \"Nat Gordon Inc.\", ratifiant son règlement N° 22, augmentant son capital de $40,000 à $100,000 par la création de 150 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune et de 450 actions privilégiées de $100 chacune et sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 19 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.International Laces Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"International Laces Incorporated\" ratifying: 1° its By-Law No.23 reducing its capital stock from $20,000 to $14,000 by the cancellation of 600 common shares of $10 each; 2° its By-Law No.24 increasing its capital stock from $14,000 to $164,000 by the creation of 1,500 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office cf the Attorney General, this 14th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Overseas Textiles Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Overseas Textiles Ltd.\", ratifying its By-Law No.4 increasing its authorized capital stock from $49,000 to $249.000 by the creation of 2,000 preferred shares of $100 each, carrying the rights, restrictions and privileges mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 14th day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Nat Gordon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Nat Gordon Inc.\", ratifying its By-law No.22 increasing its capital stock from $40,000 to $100,000 by the creation of an additional 150 common shares of $100 each and 450 preferred shares of $100 each and subject to the privileges and restrictions mentioned in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 19th day of January, 1951.^ L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General. 632 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 février 1951, Tome 83, N° 7 North American Utilities Corporation North American Utilities Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies ,Act, supplementary letters accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- patent bearing date the twenty-third day of Ja-vince de Québec des lettres patentes supplémen- nuary, 1951, were issued by the Lieutenant-Gov-taires, en date du 23 janvier 1951, à la compagnie ernor of the Province of Quebec, to the company \"North American Utilities Corporation\", rati- \"North American Utilities Corporation\", ratifiant son règlement spécial \"B\" augmentant son fying its special by-law \"B\" increasing its au-capital-actions autorisé de $4,000,000 à $8,000,000 thorized capital stock from $4,000,000 to $8,000,-par la création de 40,000 actions privilégiées addi- 000 by the creation of 40,000 additional preferred tionnelles de $100 chacune, comportant les mê- 'shares of $100 each, subject to the same rights, mes droits, privilèges et restrictions que les ac- privileges and restrictions as those of the already tions privilégiées antérieurement autorisées.authorized preferred shares.Daté du bureau du Procureur général, le 23 Dated at the office of the Attorney General, Janvier 1951.this twenty-third day of January, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29464-o L.DÉSILETS.29464 Deputy Attorney General.Paul Guimond Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 22 janvier 1951, à la compagnie \"Paul Guimond Limited\", ratifiant: 1° son règlement spécial \"A\", réduisant son capital de $24,000 à $7,000 par l'annulation de 3,400 actions ordinaires de $5 chacune; 2° son rèdement spécial \"B ', augmentant son capital de $7,000 à $47,C03 par 11 créat:on de 400 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 22 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.R.E.Stewart Construction Corporation.Paul Guimond Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Paul Guimond Limited\", ratifying: 1.its Special Bylaw \"A\" reducing its capital stock from $24,000 to $7,000 by the cancellation of 3.400 common shares of $5 each; 2.its Special By-law \"B\" increasing its capital stock from $7,010 to $47,000 by the creation of 400 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 22nd day of January, 1951.\u201e L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.R.E.Stewart Construction Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la letters patent, bearing date the 23rd day of province de Québec, des lettres patentes sup- January, 1951, were issued by the Lieutenant- plémentaires en date du 23 janvier 1951, à la Governor of the Province of Quebec, to the com- compagnie \"R.E.Stewart Construction Corpo- pany \"R.E.Stewart Construction Corporation\", ration\", ratifiant son règlement spécial \"A\", ratifying its Special By-law \"A\" increasing its augmentant son capital autorisé de $49,000 à authorized capital stock from $49,000 to $349,- $349,000 par la.création de 3,000 actions privi- 000 by the creation of 3,000 preferred shares of légiées de $100 chacune, sujettes aux droits, $100 each, subject to the rights, restrictions and restrictions et privilèges énumérés audit règle- privileges enumerated in the said by-law.ment.Daté du bureau du Procureur général, le 23 Dated at the office of the Attorney General, Janvier 1951.this 23rd day of January, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29464 L.DÉSILETS.29464-0 Deputy Attorney General.Robert M.Miller Construction Co.Ltd.Robert M.Miller Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la letters patent, bearing date the 31st day of Jan-province de Québec, des lettres patentes sup- uary, 1951, were issued by the Lieutenant-plémentaires en date du 31 janvier 1951, à la Governor of the Province of Quebec, to the com-compagnie \"Robert M.Miller Construction pany \"Robert M.Miller Construction Co.Ltd.\", Co.Ltd.\", ratifiant son règlement spécial \"D\" its Special By-law \"D\" reducing its capital stock diminuant son capital de $150,000 à $72,000 from $150,000 to $72,000 by the cancellation of par l'annulation de 780 actions privilégiées rem- 780 redeemed preferred shares of $100 each, boursées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 31 Dated at the office of the Attorney General, Janvier 1951.this 31st day of January, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29464 L.DÉSILETS.29464-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1941, Vol.83, No.7 633 Roslyn Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 janvier 1951, à la compagnie \"Artik Ice Cream Co.Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 novembre 1944: 1° changeant son nom en celui de \"Roslyn Enterprises Ltd.\"; 2° étendant ses pouvoirs et modifiant les dispositions des lettres patentes de ladite compagnie.Daté du bureau du Procureur général, le 19 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Standard Cottons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Lci des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouveneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 janvier 1951, à la compagnie \"Standard Cottons Ltd.\", ratifiant son règlement spécial \"A\": 1°) subdivisant et convertissant ses 200 actions ordinaires de $100 chacune en 600 actions catégorie \"A\" de $25 chacune et en 5,000 actions catégorie \"B\" de $1 chacune: 2°) augmentant son capital de $20,000 à $500,000 par la création de 1,000 actions catégorie \"A\" additionnelles de $25 chacune et de 5,000 actions catégorie \"B\" additionnelles de $1 chacune et de 45,000 actions privilégiées de $10 chacune et indiquant les droits et restiicticns attachés auxdites différentes actions.Daté du bureau du Procureur général, le 18 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Sterling Teas & Coffees Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 15 janvier 1951, à la compagnie \"Sterling Teas & Coffees Limited\", ratifiant: 1° son règlement N° 24, subdivisant ses 490 actions de $100 chacune en 1960 actions de $25 chacune; 2° son règlement N° 25 convertissant 1160 actions ordinaires de $25 chacune en 1160 actions privilégiées de $25 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 15 janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Sauquoit Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 22 décembre 1950, à la compagnie \"G ran by Textiles Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 23 juin 1942: a) changeant son nom en celui de \"Sauquoit Ltd.\"; b) ratifiant son règlement N° 14, changeant la situation du siège social de ladite compagnie de Granby à Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 22 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Roslyn Enterprises Ltd.Notice is hereby given that.under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of January 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Artik Ice Cream, Inc.\", incorporated by letters patent dated November 25th, 1944: 1.changing its name to that of \"Roslyn Enterprises Ltd.\"; 2.extending its powers and modifying the provisions of the letters patent of the said company.Dated at the office of the Attorney General, this 19th day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Standard Cottons Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Standard Cottons Ltd.',, ratifying its Special By-Law \"A\": 1.subdividing and converting its 200 common shares of $100 each into 600 class \"A\" shares of $25 each and 5,000 class \"B\" shares of $1 each; 2.increasing its capital stock from $20,000 to.$500,000 by the creation of 1,000 additional class \"A\" shares of $25 eac h and 5,000 additional class \"B\" shares of $1 each and 45,000 preferred shares of $10 each and indicating the rights and restrictions attaching to the said various shares.Dated at the office of the Attorney General, this 18th dav of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General.Sterling Teas & Coffees Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Sterling Teas & Coffees Limited\", ratifying: 1.its By-Law N° 24 subdividing its 490 shares of $100 each into 1960 shares of $25 each; 2.its By-lsaw No.25 converting 1160 common shares of $25 each into 1160 preferred shares of $25 each, subject to the rights and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 15th dav of January, 1951.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Sauquoit Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Granby Textiles Limited\", incorporated by letters patent dated June 23rd, 1942: a) changing its name to that of \"Sauquoit Ltd.\"; b) ratifying its By-law No.14 changing the location of the head office of the said company from Granby to Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the 22nd day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-0 Deputy Attorney General. \u20ac34 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 18 février 1951, Tome 83, N° 7 Sterling Sales & Salvage Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 décembre 1950, à la compagnie \"Sterling Sales & Salvage Co.\", ratifiant son règlement N° 54: a) subdivisant 100 actions ordinaires de $100 chacune de son capital autorisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune; b) créant et émettant les 300 actions ordinaires restantes de $100 chacune dudit capital autorisé comme 309 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 18 décembre 1950.LAssistant-procureur général, 29464 L.DÉSILETS.Sterling Sales & Salvage Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Sterling Sales & Salvage Co.\", ratifying its By-law No.54: a) subdividing 100 common shares of $100 each of its authorized capital into 1,000 shares of $10 each; b) creating and issuing the 300 remaining common shares of $100 each of the said authorized capital as 300 preferred shares of $100 each carrying the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 18th day of December, 1950.L .DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.The Cradoc Simpson Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a \u2022été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 décembre 1950, à la compagnie \"The Cradock Simpson Company\", ratifiant son règlement spécial \"A\", augmentant son capital de $10,000 a $110,000 par la création de 10,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 21 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29464 L.DESILETS.Ventes pour taxes The Cradoc Simpson Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The Cradock Simpson Company\", ratifying its Special By-law \"A\" increasing its capital stock from $10,000 to $100,000 by the creation of 10,000 preferred shares of $10 each, subject to the rights and restrictions mentioned in such by-law.Dated àt the office of the Attorney General, this 21st day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29464-o Deputy Attorney General.Sales for Taxes ERRATUM Dans l'avis de vente pour taxes du Comté de Labelle, publié dans la Gazette officielle de Québec du 20 janvier 1951, page 235, et du 27 janvier 1951, page 363, concernant le canton Marchand, lire: 11 rang sud-est, L.DeLadurantaye et non pas 11 rang 7: Pour le canton Mousseau, page 236 et page 364 lire: 8 rang 3 et non pas 8 rang 8.L'Assist-Secrétaire-Trésorier du Comté de Libelle.29480-o ROGER MUNN.ERRATUM In the Notice of sale for taxes of the County of Labelle, published in the Quebec Official Gazette the 20th January, 1951, on page 235, and the 27th January, 1951, on page 363, Concerning Marchand Township, please read: 11 south-east range, DeLadurantaye, instead of 11 range 7: Concerning Mousseau Township, page 236 and page 364, please read: 8 range 3 instead 8 rang 8; ROGER MUNN, 29480-o Ass.-Secy-treas.of Labelle County.Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Municipalité du comté d'Abitibi Municipality of the Countv of Abitibi Avis public vous est par les présentes donné Public notice is hereby given by the under- par le soussigné, Laval Goulet, secrétaire-trésorier signed, Laval Goulet, secretary-treasurer of the de la Corporation Municipale du comté d'Abitibi, Municipal Corporation of the county of Abitibi que les immeubles avec bâtisses, circonstances et that the immovables, with buildings, cireums- dépendances, ci-après mentionnées seront ven- tance and dependencies, hereinafter mentioned, dues à l'enchère publique au Palais de Justice will be sold by public auction in the Court House à Amos, au lieu ordinaire des sessions de ce at Amos, the usual meeting place of the said conseil le second jeudi du mois d'avril 1951, soit Council, on the second Thuisday of the month le DOUZE AVRIL, 1951, à DIX heures de of April, 1951, namely the TWELFTH day of Pavant-midi, pour non-paiement des taxes muni- APRIL, 1951, at TEN o'clock in the forenoon, cipales, scolaires et repartition d'Église, frais for the non-payment of municipal and school et charge dues sur chacun de ces immeubles à taxes and church apportionments, costs and moins que ces taxes, frais et charges ne soient charges due on each of the said immovables, plus tôt payés et acquittés avec les frais encourus unless the said taxes, costs and charges be paid avant la vente, savoir: and acquitted, with costs incurred, before the sale, to wit: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1961, Vol.83, No.7 635 Canton ou village Township or village Carpentier.Courville.Senneterre Courville.Rang R*ge 6.6.6.6.6.7.7.8.8.9.9.9.9.9.9.9.9.10.10.10.10.10.10.10.Bloc Block 16.17 Lot 51-A-B .54.P.S.61-A-B & 62-A-B.50.54.55.56.58.57.58-1-2-3-4.-, 61.62.34-1-2.35-1-2.51-1-2-3-4.53-1-2-3-4- .55-1-2-3-4.P.S.60.61-1-2.62-1-2.60.34-1-2.35-1-2.36-1-2.37-1-2.38-1-2.52.57.6H.5.6.7.9.7.44-1-2.45-1-2.Propriétaire Owner Gaudias Labbé.Emery Desputeau.Georges Otis.Lauren zo Bel isle.-.Nestor Biais.Arthur Bouchard.Léo Lavergne.Léo Lavergne.Lucien Béiand.Nestor Biais.Raoul Roy.Raoul Roy.Lucien Raymond.Charles Pratte.Philippe Vilandré.Nelson Belisle.Maurice Lavoie.Sylva St-Amant.Alexandre Lauzé.Alexandre Lauzé.Société Coopérative Lucien Raymond.Charles Pratte.Léandre Lafrance.Alphée Richard.Pascal Richard.Alphonse Petit.Emile Lacourse.Jean-Louis Bacon.René Labonne.Joseph Bourgeault.Joseph Bourgeault.Joseph Bourgeault .Georges Grosleau.Georges Cayer.Georges Cayer.Taxes\tTaxes\t munie.\tsco.\t \u2014\t\u2014\tTotal Munie.\tSchool\t taxes\ttaxes\t s 4.58\ts 42.02\ts 46.60 21.69\t150.18\t171.87 2.95\t17.65\t20.60 15.45\t104.27\t119.72 32.16\t64.80\t96.69 .18.22\t27.66\t45.88 20.90\t56.09\t76.99 8.53\t19.60\t28.13 17.91\t50.03\t67.91 6.30\t12.30\t18.26 17.22\t117.56\t134.78 4.87\t41.06\t45.93 4.05\t14.87\t18.92 17.68\t56.09\t73.77 19.59\t81.25\t100.84 30.13\t178.31\t20S.44 16.53\t53.67\t70.10 10.89\t67.56\t78.45 21.38\t40.20\t61.58 17.45\t28.96\t46.41 19.93\t84.21\t106.14 2.35\t8.25\t10.60 7.88\t11.14\t19.02 8.22\t17.05\t25.27 8.00\t15.02\t23.02 7.60\t38.18\t45.78 9.62\t43.27\t52.89 3.06\t15.01\t18.07 13.25\t95.73\t108.93 7.00\t19.70\t26.70 21.34\t82.25\t103.59 6.65\t25.71\t32.36 6.65\t25.59\t32.24 35.77\t90.53\t126.30 9.95\t4.00\t13.95 40.43\t20.11\t60.54 Commission scolaire de Saint-Benoit de Lacorno \u2014 School Commission of Saint-Benoit do Lacorne \t4\t\t6.\t\t\t32.31\t32.31 \t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale de Sainte-Hélène \u2014 Municipal Corporation of Sainte-Hélène Commission scolaire de Sainte-Hélène \u2014 School Commission of Sainte-Hélène\t\t\t\t\t\t\t \t2\t\t59.\t\t4.42 .4.38\t43.05 43.89\t47.47 48.27 \t3.,\t\t5.\tJ.-E.Carbonneau.\t\t\t Corporation de Saint-Jacques de Dupuy \u2014 Corporation of Saint-Jacques de Dupuy Commission scolaire de Dupuy \u2014 School Commission of Dupuy \t4\t\t49.\t\t9.37\t37.69\t47.26 \t3\t\t53.\t\t13.73\t37.49\t51.22 \t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale de Colombourg \u2014 Municipal Corporation of Colombourg Commission scolaire de Colombourg \u2014 School Commission of Colombourg \t10\t\t38.\t\t16.69\t38.75\t65.44 \t10\t\t40.\t\t7.92\t17.50\t25.42 \t1\t\t53.\t\t18.82\t55.55\t74.38 \t2\t\t25.\t\t17.05\t65.10\t82.15 0, au A maximum £), au A maximum of forty-five and a half (45^) maximum, constituent une semaine régulière de hours constitute a standard work week for travail pour les ateliers de la classe \"D\" du establishments of class \"D\" of the judicial district judiciaire de Québec, le, département de district of Quebec, for the aniline press depart- presses à l'aniline des manufactures de sacs en ment of paper bag factories and for all establish- papier et tous les ateliers des districts judiciaires ments of judicial districts other than that of autres que celui de Québec.Cette semaine Quebec.This standard work week of forty-five régulière de quarante-cinq heures et demie (45^) and a half (45>£) hours for day shifts in establish- pour les équipes de jour des ateliers et départe- ments and departments mentioned in the present ments mentionnés dans le présent alinéa peut paragraph may be distributed equally over the être répartie également dans les cinq (5) pre- first five working days of the week.A maximum miers jours ouvrables de la semaine.Neuf of nuie hours and six minutes constitute a heures et six minutes, au maximum, constituent regular work day for the day shifts of such une journée régulière de travail pour les équipes establishments, de jour de ces ateliers.b) Pour les équipes de nuit, les heures de b) As for the night shifts, the working hours travail sont réparties entre les heures régulières are distributed between the regular finishing and de la fin et du commencement de l'équipe de jour, starting time of the day shift.Trente-neuf heures et demie (39>é), au maxi- A maximum of thirty-nine hours and a half mum, constituent une semaine régulière de tra- (39^) constitute a standard night-work week vail de nuit, sauf pour les ateliers des districts except as regards the establishments in judicial judiciaires autres que celui de Québec où la districts other than that of Quebec where the semaine régulière est de quarante-deux heures standard week is one of forty-two and a half et demie (42^).(42^) hours.¦y QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vcl.83, No.7 649 Pour tous les ateliers assujettis au décret, huit heures et demie (83^) au maximum, constituent une nuit régulière de travail.c) Nonobstant les dispositions précédentes, dans les manufactures de boites en carton, la durée régulière de travail est de quarante-huit (48) Jieurcs par semaine; le surtemps doit être payé après la journée normale de travail, au taux de salaire et demi.d) La période de travail pour laquelle le salarié a droit au salaire comprend, outre les heures ou fractions d'heures où, en fait, il travaille, celles aussi durant lesquelles il est à la disposition de l'employeur et obligé d'être présent, y compris le temps où, appelé pour une certaine heure, il attend qu'on l'emploie.Cette règle s'applique quel que soit le mode de travail, soit à l'heure ou autrement.Toutefois, le temps mis à la disposition du salarié pour prendre ses repas ou durant lequel il est bien entendu que ses services ne sont pas requis, n'est pas compté dans ses heures de travail.e) A compter du premier janvier 1952, la semaine régulière de travail actuelle sera diminuée de deux heures et demie (2%) dans tous les ateliers.V.Taux de salaire minima: Les taux de salaire minima sont les suivants: a) Travail de jour: Classe \"A\": L'heure Typographe, operateur de claviers et tondeuses, électrotypeur.SI .33 Finisseur-doreur en reliure.1.33 Pressier et clicheur.1.30 Relieur.1.25 Photograveur et opérateur de caméra.1.25 Aide: 1ère année.0.43 2ème année.0.47 Classe \"B\": Typographe, opérateur de claviers et fondeuses.1.28 Finisseur-doreur en reliure.1.28 Pressier et clicheur.1.26 Relieur.1.22 Aide: 1ère année.0.43 2ème année.>.0.47 Classe \"C\": Typographe, opérateur de claviers et fondeuses.1.23 Finisseur-doreur en reliure.1.23 Pressier et clicheur.:.1.21 Relieur.1.18 Aide: 1ère année.\u2022.0.43 2ème année.\u2022.0.47 Classe \"D\": Pressier sur cylindre.1 - 08 Pressier sur plateau.1.00 Typographe.1.00 Classe \"E\": Relieur.1.16 Finisseur-doreur en reliure.1.19 6) Travail de nuit: Tous les compagnons travaillant sur l'équipe de nuit doivent recevoir $3.00 de plus par semaine que le salaire régulier des salariés travaillant le jour.c) Contremaîtres: Les salaires des contremaîtres, dans un atelier doivent être d'au moins $5.00 de plus par semaine que ceux des compagnons dans la classe \"A\", de $4.00 dans les.classes \"B\" et \"C\" et de S3.00 dans les autres classes, et lesdits contremaîtres sont soumis aux mêmes heures et aux mêmes conditions que les compagnons.t d) Apprentis: Les apprentis doivent recevoir les salaires minima suivants, basés sur leur certificat de qualification.The maximum daily duration of night work in all establishments hereby governed is eight and a half (8%) hours.c) Notwithstanding the foregoing provisions, in paper box factories the regular weekly duration of work is forty-eight (48) hours.Overtime shall be paid after the regular daily duration of work at the rate of time and a half.d) The time for which the employee is entitled to remuneration includes, besides the hours or fractions of hours of actual work, those during which he is at the disposal of the employer and required to be present, including any period of forced idleness from the time for which he has been called.This rule applies to all employees, whether paid on an hourly or other basis.However, the period allowed to the employees for their meals or that during which it is well understood that their services are not required is not considered as working time.e) From January 1, 1952, the actual standard work week shall be reduced by two and a half (2^0 hours in all shops.V.Wages rates: The minimum wage rates are as follows: a) Day Shift : Class \"A\": , Per hour Typographer, keyboard, caster operator and electrotyper.SI.33 Bookbinding finisher-gilder.1.33 Pressman and stereotyper.1.30 Bookbinder.1.25 Photo-engraver and camera operator.1.25 Helper: 1st year.0.43 2nd year.0.47 Class \"B\": Typographer, keyboard and caster operator.1-28 Bookbinding finishing-gilder.1.28 Pressman and stereotyper.1.26 Bookbinder.1-22 Helper : 1st year.0.43 2nd year.0.47 Class \"C\": Typographer, keyboard and caster operator.1-23 Bookbinding finisher-gilder.1 \u2022 23 Pressman and stereotyper.1.21 Bookbinder.1-18 Helper: 1st year.0.43 2nd year.0.47 Class \"D\": Pressman on cylinder.1.08 Pressman on platen press.1 00 Typographer.1 00 Class \"E\": Bookbinder.116 Bookbinding finisher-gilder.1.19 b) Night shift: Journeymen on night shifts shall receive $3!fJ0 more per week than the regular rates established for day workers.c) Foremen: Wages of foremen, according to their particular trade, shall be at least five ($5.00) dollars more per week than those of journeymen in class \"A\", four (§4.00) in classes \"B\" and \"C\", and three ($3.00) dollars in the other classes, and said foremen are subject to the same hours arid working conditions as those of journeymen.d) Apprentices: Apprentices shall receive the following minimum wages based on their competency card : 650 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Terne 83, N° 7 Par semaine: Classes \"A\" \"B\"-\"C\" \"D\"-\"E\" 1ère année.$16.00 $15.00 $15.00 2ème année.20.00 19.00 18.00 3ème année.23.00 22.00 20.00 4ème année.26.50 25.50 22.50 5ème année, premier semestre.30.00 29.00 26.00 5ème année, deuxième semestre 35.00 34.00 31.00 Ces salaires sont payables sur la base horaire.e) Les aides sur fondeuses doivent recevoir le salaire prévu pour les apprentis jusqu'à concurrence de la quatrième année inclusivement.Après quatre (4) années de service, ils doivent recevoir une augmentation de dix pour cent (10%) par année jusqu'à ce qu'ils atteignent le salaire de compagnon; cette augmentation de dix pour cent (10%) doit être ajoutée au salaire hebdomadaire du salarié.11 n'est pas permis d'employer un aide-fondeur avant d'avoir au moins un (1) compagnon opérateur de fondeuse (raster-man) au travail.Le nombre d'apprentis dans les autres départements ne doit pas être réduit par le nombre d'aides sur fondeuses./) Travail de nuit des apprentis: Les apprentis travaillant de nuit doivent recevoir $2.00 de plus par semaine que le salaire régulier des apprentis travaillant le jour.g) Les filles du département de reliure doivent recevoir: Par semaine 1ère année, 1er semestre.$14.00 1ère année, 2ème semestre.15.00 2ème année, 1er semestie.16.00 2ème année, 2ème semestre.17.00 3ème année, 1er semestre.18.00 3ème année, 2ème semestre.19.00 4ème année, 1er semestre.21.00 4ème année, 2ème semestre.22.00 Ces salaires sont payables sur la base horaire.h) Dans les districts judiciaires autres que celui de Québec, la cédule des salaires peut, toutefois, être réduite de dix pour cent (10%), et le travail supplémentaire être rémunéré au taux de salaire et demi.VI.Travail supplémentaire: a) Tout travail exécuté par un salarié régulier ou surnuméraire en plus de3 heures régulières stipulées aux paragraphes \"a\" et \"b\" de l'article IV, qu'il s'agisse d'une même journée, d'une même nuit ou d'une même semaine régulière, ou en dehors des limites horaires déterminées au premier alinéa du paragraphe \"o\" du même article, est considéré comme du travail supplémentaire et doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport au salaire régulier, excepté dans les cas mentionnés ci-dessous.b) Aucun employeur n'a le droit d'exiger qu'un salarié ait fait une journée ou une semaine complète de travail pour recevoir le taux de salaire supplémentaire, sauf si ledit salarié, dans les classes \"D\" et \"E\",-n'a pas travaillé 24 heures au cours de la semaine normale de travail précédente.Dans ce cas, le travail supplémentaire d'une journée ne doit pas excéder quatre (4) heures et doit être rémunéré au taux simple.c) Toutefois, le salarié peut, recevoir une rémunération basée sur son salaire régulier pour le travail supplémentaire qu'il exécute, s'il bénéficié d'un engagement annuel écrit, lui assurant un salaire hebdomadaire supérieur de dix pour cent (10%) à celui prévu au décret pour la semaine normale de travail, et s'il bénéficie, en plus, de \"A\" ' 1st year.$16.00 2nd year.20.00 3rd year.23.00 4th year.26.50 5th year : first six months .30.00 5th year : second six months.35.00 Per week Classes B\"-\"C\" \"D\".\"E\" $15.00 $15.00 19.00 22.00 25.50 18.00 20.00 22.50 29.00 26.00 34.00 31.00 These wages are payable on the hourly basis.e) Castcrmen's hel]>ers shall receive the wages stipulated for the apprentices up to the rate fixed for the fourth year inclusive.After four (4) years, their wages shall be increased by ten per cent (10%) every year until they attain those established for journeymen.Such 10% increase shall be added to the weekly wages of the employee.No castennan's helper may be employed unless a minimum of one (1) journeyman caster-man be at work.The number of apprentices in other departments shall not be affected by the number of castcrmen's helpers./) Night work of apprentices: Apprentices doing night work shall receive two ($2.00) dollars more per week than the regular wage rate of apprentices doing day work.g) Bookbinding female employees shall receive : Per week 1st year, first six months.$14.00 1st year, second six months.15.00 2nd year, first six months.16.00 2nd year, second six months.17.00 3rd year, first six months.18.00 3rd year, second six months.19.00 4th year, first six months.21.00 4th year, second six months.22.00 The above wages are payable on an hourly basis.h) In judicial districts other than that of Quebec, the wage scale may be reduced by ten percent (10%) and overtime may be paid at the rate of time and a half.VI.Overtime: a) Time worked by a regular or occasional employee in excess of the standard hours mentioned in subsections \"a\" and \"b\" of section IV, in a same day, a same night or a same regular week, or outside the periods of work determined in the first paragraph of subsection \"a\" of the same section, is considered as overtime and remunerated at the rate of time and a half based on the regular rate, with the exception of the cases hereunder referred to.6) No employer has the right to exact that an employee have worked a complete day or week of labour to pay him to overtime rate except when the said employee, in classes \"D\" and \"E\" has not worked 24 hours in the course of the preceding standard week of work.In such case, overtime work in one day shall not exceed four (4) hours and may be paid single rate.c) However, for overtime work, the worker may be paid on the basis of his regular rate in the case of an annual written employment contract with his employer by which he is assured of weekly wages 10% higher than the weekly rate established by the decree for the normal week of labour and if he is entitled to a vacation with QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 651 congés payés, du paiement de son salaire en cas d'absence pour cause de maladie soit, en ce dernier cas, de quinze (15) jours par année.d) Le salaire double doit être payé pour tout travail exécuté le dimanche, la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail.e) En plus de la rémunération stipulée au paragraphe a) de l'article VIII, les fêtes suivantes, lorsque travaillées, doivent être rémunérées au taux douhle: le Premier de l'An; l'Epiphanie; l'Ascension; la Toussaint; l'Immaculée Conception et le jour de Noël.Le même principe s'aprjique pour les ateliers protestants qui auront substitué d'autres fêtes à celles mentionnées ci-dessus./) Tout salarié appelé, après avoir quitté l'atelier, pour exécuter du travail régulier ou supplémentaire, doit recevoir une rémunération équivalente à au moins trois (3) heures de travail.VII.Congés payés: a) tout salarié régi par le décret a droit: i.Après un an de service continu pour son employeur, à un eonfjo annuel continu payé d'une durée minimum de sept jours; ii.En plus, tous les compagnons, à l'exception des filles de reliure, ont droit chaque année, à trois (3) jours additionnels de vacances payées, le choix de ces jours étant laissé à la discrétion de l'employeur.iii.S'il n'a pas un an de service continu pour son employeur, à un congé annuel eontinu payé d'une durée minimum d'autant de demi-jours qu'il a de mois (30) de service continu*pour son employeur.6) Services continus: La durée des services continus doit s'entendre de la période pendant laquelle e salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-c a été interrompu sans qu'il y ait résiliation de contrat.Ne sair raient notamment être considérés comme interrompant la durée des services continus, les jours de maladie, si le contrat n'a pas été résilié, les jours de fermeture, les périodes de congé annuel, de délai-congé, les absences autorisées si le travailleur n'a pas occupé, pendant ces journées, un autre emploi rémunéré.c) Période de service continu donnant droit au congé: Pour chaque congé annuel payé, la période de serviec continu pour son employeur donnant droit à'tel congé, s'établit du premier mai d'une année au trente avril de l'année subséquente.d) Rémunération: Le salarié a droit, pour son congé, à une rémunération équivalente: i.au salaire de la semaine.normale de travail établie par le décret au moment de la prise de son congé, s'il a une année de service continu pour le même employeur au trente avril.ii.en plus, les trois (3) jours additionnels accordés aux compagnons, tel que prévu au paragraphe \"a\", alinéa ii de ce même article seront rémunérée sur la base de cinquante pour cent (50%) du salaire de la semaine normale de travail établie par le décret au moment de la prise de congé.iii.à autant de douzième de son salaire basé sur la semaine normale de travail établie par le décret au moment de la prise de son congé, qu'il a de mois (30 jours) de service continu poyr le même employeur; et ce, s'il a moins d'un an d'emploi pour ledit employeur., e) Echéance de la rémunération: Avant le départ du salarié visé par les paragraphes \"a\" et \"b\" du présent article, l'employeur doit lui payer sa rémunération pour congé./) Période de prise de congé: Chaque congé doit être donné dans les douze mois de la date à la- pay, and to the payment of his wages in the case of absence on account of sickness to the extent of fifteen (15) days per year.d) Double time shall be paid for work per-ormed on Sunday, St.Jean Baptiste Day and Labour Day.e) Notwithstanding the remuneration provided for under subsection \"a\" of section VIII the following holidays, when worked, shall be remunerated at the rate of double time: New Year's Day, Epiphany Day, Ascension Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day and Christmas Day.The same policy applies to sliops which have replaced the above-mentioned holidays by other ones./) Any employee called, after he has left he shop, to perform regular or extra work, hall receive a minimum of three (3) hours' pay.\u2022 VII.Vacation with pay.a) Every employee governed by the decree is entitled: i.after one year of continuous service for his employer, to an annual continuous vacation with pay of at least seven days, and ii.Moreover, all journeymen, with the exception of bookbinding female employees, are entitled, each year, to three additional days of vacation with pay, the date thereof to be fixed by the employer.iii.when he has less than one year of continuous service for his employer, to an annual continuous vacation with pay of at least as many half-days as he has months (30 days) of conti-nous service for his employer.b) Continuous service.The duration of continuous service shall be the period during which the employee is bound by a labour contract with his employer, even if the carrying out of the said contract has been interrupted without annulment thereof.The duration of continuous service should not be considered as being interrupted especially in cases of illness, when the contract has not been annulled, of days of closing, of annual vacation periods, of terms of notice, of authorized absences if, during these days, the employee has not done remunerated work.c) Period of continuous service which gives the right to a vacation: The period of continuous service for an employer which entitles ah employee to an annual vacation with pay extends from May 1 of one year to April 30 of the following year.d) Remuneration.The employee is entitled, for his vacation, to a remuneration equivalent: i.to the wages which he wordd have received if he had been working during his vacation period if he has, on April 30, one year of continuous service for the same employer.ii.besides, the three additional days granted to journeymen, as provided for in subsection \"a\", paragraph \"ii\", of this section, shall be paid on the basis of fifty.per cent (50%) of the wages for the standard work week, as establish in the decree at the time of such holidays.iii.to as many twelfths of his wages, computed on the standard work week as established in the decree at the time of vacation, as he has months (30 days) of continuous service for the same .employer, in the case of his having less than one year of service for the said employer.e) Payment of vacation remuneration.The employees referred to in subsections \"a\" and \"b hereof shall be given their vacation pay by their employer before they leave for said vacation./) Period of vacation.Every vacation shall be given whithin the twelve months following the 652 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 88, N° 7 quelle le droit à tel congé est acquis, i.e.au 1er mai de chaque année.g) Fixation de la période de congé: Le salarié a droit de connaître au moins quinze (15) jours à l'avance, la période de son congé.h) Congé obligatoire: Il est interdit à un em ployeur de remplacer par une indemnité compensatrice tout congé annuel payé prescrit par le décret.VIII.Fêtes payées: a) Lorsque chômées et ouvrables, les fêtes suivantes doivent être payées au taux des heures régulières de travail: le Premier de l'An, l'Epiphanie, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Travail, la Toussaint, l'Immaculée Conception et le jour de Noël.Toutefois, pour bénéficier de ces fêtes payées, le aslarié doit avoir travaillé le dernier et le premier jour«ouvrable qui précède et suit la fête, à moins d'une r.i oi valable, ou après avoir obtenu la permission de son employeur.Dans le cas de li.i;e pour l'interprétation de \"raison valable\" le comité Paritaire en sera le juge.6) Advenant le cas où le Premier de l'An et le jour de Noël tombent le dimanche et que le lendemain soit chômé par ordre de l'employeur les Sidarics doivent être payés au taux des heures régulières de travail pour cette journée chômée.c) H est loisible aux ateliers protestants de substituer d'autres fêtes payées à celles mentionnées au paragraphe \"a\" de ce même article, en les déterminant et en en faisant la demande au comité paritaire dans les trente (30) jours qui suivent la date de la mise en vigueur du décret.Il va sans dire que cette clause reste dépendante, dans son application, de toutes celle:; qui peuvent s'y rattacher directement ou indirectement.IX.\u2014 Apprentissage: a) Tout apprenti commençant l'étude de son métier doit avoir seize (16) ans révolus et ne pas être âgé de plus de vingt-cinq (25) ans.La durée de l'apprentissage est déterminée par le bureau des examinateurs et se termine avec l'émission d'une carte de compagnon, après que l'apprenti ait obtenu avec succès ses certificats de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, sauf tel que prévu au paragraphe \"f\" du présent article.b) Dans le cours du premier mois dp l'entrée en fonction d'un apprenti, l'employeur ou ses maîtres ou professeurs doivent avertir, par écrit, le secrétaire du Comité Paritaire de telle entrée en fonction et l'apprenti doit se présenter devant le Bureau des Examinateurs afin de démontrer ses aptitudes pour telle branche de l'imprimerie qu'il désire apprendre.Si nécessaire, la production d'un certificat médical peut être exigée.Si le futur apprenti est jugé apte physiquement et intellectuellement et a obteru le degré d'instruction exigé dans la branche de l'imprimerie qu'il désire apprendre, le torrt conformément aux dispositions énumérées ci-après il est ipso-facto accepté.Mais s'il ne réussit pas à passer son examen de manière satisfaisant te, on lui conseillera de se diriger vers un champ d'action mieux approprié à ses aptitudes et l'employeur ou ses maîtres ou professeurs en seront avertis aussitôt.c) Les heures de travail des apprentis sont les mêmes que celles des compagnons.Il n'y a du travail supplémentaire per les apprentis dans un atelier que si la proportion des compagnons par rapport aux apprentis, telle qu'établie dans le décret, est observée.d) Les salariés du sexe féminin qui apprennent et exercent un des métiers régis par le décret, gé- date on which the right to such vacation has been acquired, i.e.May 1st of each year.g) Setting of vacation period.Every employee shall be informed of the period of his vacation at least fifteen (15) days in advance.h) Compulsory vacation.No employer may replace by a compensating bonus the annual vacation with pay prescribed by the decree.VIII.Holidays with pay: a) When the following days are working days but are not worked by the employees, they shall be paid at the rate of the regular hours of work : New Year's Day, Epiphany Day, Ascension Day, St.Jean Baptiste Day, Labour Day, All Saints Day, Immaculate Conception and Christmas Day.However, to be entitled to these holidays with pay, the employee must have worked the last and the first working day prece ling and following the said holidays except for sufficient, reason or when ant h >rized to do so by his employer.Should a dispute arise over the\"' interpretation of \"sufficient reason\", the decision lies with the Parity Committee.6) In the event of New Year's Day and Christmas Day falling on Sunday and of the following clay not being worked by order of the employer, the' employees shall be paid at the rate fixed for reg rlar working hours for such day off.c) Shops which do not observe all of the ordinary reli ious holidays may substitute other holidays with pay for tlio e menti >ned in subsection \"rf\" of this section by determining same and applying to the Parity Committee within thirty (30) days after the date of the coming into force of the decree.In its enforcement, however, this clause is subject to any other which may have any connection therewith, either directly or indirectly.IX.Apprenticeship, a) Any apprentice beginning to learn his trade should be at least 16 years old and not more than 25.The duration of the apprenticeship is determined by the Competence Committee and ends with the issue of a journeyman's card after the apprentice has obtained his first, second, third, fourth and fifth year card, except as provided for under subsection \"/\" of this section.b) In the course of the first month of service of an apprentice, the employer or his teachers shall give a written notice thereof to the secretary of the Joint Committee, and the apprentice shall sit before the Board of Examiners in order to determine his fitness for such branch of the printing trade which he wishes to learn.If necessary, a medical certificate may be required.If the candidate is found physically and intellectually qualified and has obtained the degree of instruction required in the branch of the printing trade which he wants to learn, in conformity with the provisions hereinafter mentioned, he shall be accepted ipso facto.But if he docs not succeed in his examination, he will he suggested to choose a more suitable occupation and his employer or teachers shall be so informed immediately.c) The duration of labour for apprentices is the same as that established for journeymen.Overtime work may be performed by apprentices in a shop only if the proportion of the number of apprentices with regard to that of journeymen, as established in the decree, is observed.d) Female employees learning and plying one of the trades governed by the decree gene- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 653 néralement exercés par des hommes, sont soumis aux mêmes conditions de travail et aux mêmes taux de salaire que les hommes.\u2022 e) L'expérience des salariés est déterminée par le Bureau des Examinateurs.Le nombre d'heures de travail réellement effectuées, soit 42% heures par semaine et 50 semaines (2125 heures), sont nominalement considérées comme une année.En aucun temps le nombre d'heures ne doit être un facteur exclusif dans la promotion d'un salarié d'une année à l'autre ou au titre de compagnon.Aucun apprenti ne peut être promu au titre de compagnon avant d'avoir satisfait aux deux conditions ci-haut mentionnées.Pour les apprentis monotypistes et linotypistes, la compétence s'évalue à l'aptitude de chacun à composer et corriger, sur une machine normalement entretenue et dans des conditions normales, un minimum de 3,500 ems de texte courant à l'heure en moyenne./) Toutefois, au terme de son apprentissage, l'apprenti de quelque département que ce soit qui n'est pas suffisamment qualifié pour obtenir son certifi at de compagnon doit îecevoir une augmentation de pas moins de dix pour cent (10%) pour chaque période additionnelle de pas moins de six mois et de pas plus d'une année, à la discrétion du Bureau des Examinateurs, jusr qu'à ce qu'il atteigne le salaire d'un compagnon.Cette augmentation de 10% est ajoutée au salaire hebdomadaire de l'apprenti.Cependant, tel salarié, s'il travaille dans le.département des presses, ne compte pas dans le prorata dts apprentis à partir de la date où il atteint son quatrième 10% d'augmentation jusqu'à ce qu'il se qualifie comme compagnon.Dans les autres départements, cependant, les salariés qui travaillent d'après cette clause du 10% comptent comme apprentis dans le prorata.Dans les ateliers de la Classe \"D\" qui possèdent .un cylindre de quelque format que ce soit, le compagnon surpresse à plateau peut travailler sur ce cylindre et bénéficier d'une augmentation de 10% annuellement jusqu'à ce qu'il ait atteint le salaire prévu pour un compagnon pressier pour cette catégorie.Le compagnon sur presse à plateau compte comme compagnon dans le prorata, qu'il travaille ou non sur le cylindre en vertu de cette clause.g) Les présentes ne s'appliquent pas aux élèves de moins de seize (16) ans d'une institution d'assistance publique régie par la Loi de l'Assistance Publique (S.R.Q.1941, chapitre 187).X.\u2014 Nombre d'apprentis: a) Dans les ateliers de composition et de reliure, il ne doit pas y avoir plus apprenti par trois compagnons employés régulièrement ou fraction de ce nombre.b) Dans les départements des presses, de cli-cherie et dans les ateliers de photogravure, d'élec-trotypie et d'offset, il ne doit pas y avoir plus d'un (1) apprenti par deux (2) compagnons ou fraction de ce nombre.Les aides et les apprentis sujets au paragraphe \"f\" de l'article IX n'entreront pas en ligne de compte pour la détermination du nombre d'apprentis (l'un atelier.c) Le nombre des filles du département de la reliure n'ayant pas trois (3) ans et plus d'expérience ne doit pas dépasser les deux tiers du nombre total des salariés de cette catégorie.d) Toutefois, les ateliers comptant moins de dix (10) salariés, compagnons et apprentis compris, exception faite des jeunes filles du département de la reliure, bénéficient des conditions suivantes: un (1) compagnon; un-(l) apprenti; deux rally performed by men are subject to the same labour and wage conditions as those tf male employees.e) The experience of the employees is determined by the Board of Examiners.The number of hours actually worked, that is: 42^ hours for one week, and 50 weeks (2125 hours), are nominally considered as one year.In no time should the number of hours be an exclusive factor in the promotion of a worker from one year to another or to the journeyman's rank.No apprentice may be promoted to the journeyman's rank before he has complied with the above two conditions.In the case of the apprerti e-linotypiit and monotypist, the competency is estimated l>y his ability to compose and correct, on a machine in good repair, and in normal conditions, an average of at least 3,500 ems-of current text per hour./) However at the expiration of his apprenticeship, the apprentice, in any der art ment whatsoever, not suffi iently quali ied to obtain his certificate as journeyman, sirll re eive a minimum increase of 10% for e ,ch cd 'itional period of from six months to one year, r,t the option of the Board of Exami ers, until the j mr-neyman's rate is attained.Such 10% increase shall be added to the weekly wages of the apprentice.However, such employee, when working in the press department, si not counted in the prorata cf the apprentices from the date on which he gets his fourth 10% increase until he qualifies as journeyman.In the other departments, however, those working under that 10% clause are considered as ' apprentices in the prorata.In the establishments of class \"D\" operating a cylinder of any size whatever, the journeyman on a platen press may work on this cylinder and benefit by an annual 10% increase to the extent of the wage rate established for the journeyman pressman of that category.The journeyman a on a platen press is considered as journeyman in the prorata, whether working on the cylinder under this clause or not.g) This section does not apply to persons under sixteen years of age in a public relief institution subject to the Quebec Public Charities Act (R.S.Q., 1941, chapter 187).X.Number of apprentices, a) In composition and bookbinding establishments, there shall not be more than one .(1) apprentice to three (3) journeymen employed regularly or fraction thereof.&) In press or stereotyping departments, and in photogravure, electrotyping and offset establishments, there shall not be more than one (1) apprentice to each two (2) journeymen or fraction thereof.Helpers and apprentices subject to section IX, subsection \"jf\", are not taken into account for the determining of the number of apprentices in a shop c) As for girls in the bookbinding department the number of those not having three (3) or more years of experience shall not exceed the two thirds of the total number of the employees in this category.d) However, establishments with less than ten (10) workers, journeymen and apprentices included, with the exception of book-binding girls, benefit by the following proportion of appren- 654 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 88, N° 7 (2), trois (3), quatre (4) compagnons: deux (2) apprentis; cinq (5), six (6) compagnons: trois (3) apprentis.Les apprentis de ces ateliers peuvent travailler dans les différents métiers jusqu'à concurrence de la troisième année révolue; après quoi, les apprentis doivent opter pour l'un ou l'autre des métiers; le temps fait durant les trois premières années comptera pour l'obtention du certificat de qualification dans le métier pour lequel ils optent.é) Dans les ateliers où il y a deux (2) compagnons ou moins, ceux-ci peuvent travailler dans les différents métiers.Les apprentis sont sujets aux mêmes dispositions du paragraphe \"d\" du présent article./) Les compagnons et les apprentis typographes, porteurs d'une carte de cinquième année ont le droit d'exécuter du travail productif sur les machines à composer.Toutefois, tout atelier qui à cause de pénurie de main-d'œuvre ne peut se conformer à cette clause aura le droit d'employer un apprenti de quatrième année deuxième semestre lequel doit recevoir un salaire proportionnel à son rendement jusqu'à ce qu'il atteigne un rendement minimum de 3,500 cms à l'heure auquel cas il doit recevoir son salaire de compa- 8norl- g) Tous les certificats de qualification sont attribués par le Bureau des Examinateurs et non autrement.h) Les maîtres-imprimeurs, les surintendants et les contremaîtres travaillant au moins vingt-deux (22) heures par semaine dans un des métiers régis par le décret sont considérés comme des compagnons dans la fixation du nombre des apprentis par rapport à celui des compagnons.Cependant, pour les ateliers de la classe \"D\", les maîtres-imprimeurs travaillant onze (11) heures ou plus par semaine dans l'un de ces métiers sont considérés comme compagnons.t) Toutefois, tout atelier qui, à cause de pénurie de main d'oeuvre, ne peut se conformer aux clauses relatives au nombre d'apprentis, ou de filles de reliure, doit référer son cas au Comité Pari'aire.j) Les présentes ne s'appliquent pas aux élèves de moins de seize ans d'une institution d'assistance publique régie par la Loi de l'Assistance Publique (S.R.Q.1941, chapitre 187).XL Dispositions spéciales: a) Nonobstant les dispositions du décret, dans les ateliers où le nombre des heures de travail régulières formant une semaine normale est inférieur à celui des heures stipulées aux paragraphes \"a\" et \"b\" de l'article IV et où la cédule normale des salaires est actuellement plus élevée que le minimum fixé par le décret, ladite semaine normale de travail doit être maintenue et ladite cédule des salaires plus élevée doit continuer de s'appliquer à tous les salariés actuels de tels ateliers durant l'existence du décret.b) Aucun travail à la pièce ne doit être exécuté dans un atelier, excepté tel que prévu pour les graveurs, à la main sur cuivre, à l'item \"iii\" de l'alinéa \"4\" du paragraphe \"6\" de l'article IL c) Tout travail à domicile est interdit.Aucun employeur n'a le droit de donner à qui que ce soit, du travail à être exécuté à la maison; un salarié ne peut accepter un tel travail.XII.Si de nouvelles machines ou de nouveaux procédés viennent en usage pendant la durée du décret, la cédule des salaires et les conditions applicables à ces machines ou à ces procédés seront déterminées par un amendement au décret, le tout sujet à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil.tices: one journeyman \u2014 one apprentice; two, three, four journeymen \u2014 two apprentices; five, six journeymen \u2014 three apprentices.Apprentices in these shops may work in the various trades until the completion of the third year; then, apprentices shall decide upon one of the said trades.Time worked during the first three years shall be taken into account for the issue of the certificate of competency in the trade they have chosen.c) In establishments, where two (2) journeymen or less are working, these journeyman may work in the various trades.As for apprentices, the conditions of subsection \"d\" hereof shall apply.t # /) Apprentice and journeyman typographers holding a fifth year card may do productive work on composing machines.However, in any shop not able to abide by this clause because of labour shortage, the employer may employ an apprentice of the fourth year, second six months, which shall receive wages proportional to his work until he attains a minimum output of 3,500 ems per hour, in which case he is to receive the journeyman's rate of pay.g) All competency cards arc i sued only by the Board Examiners of the Parity Committee.h) Master-printers, superintendents and foremen working a minimum of twenty-two (22) hours per week in one of the trades governed by the decree are considered as journeymen for the establishing of the prorata of the number of apprentices with respect to that of journeymen.However, for the establishments of class \"D\", the master-printers working 11 hours or more per week in one of these trades are considered as journeymen.i) However, any shop unable to abide by the clauses respecting the number of apprentices, or bookbinding girls, because of labour shortage, shall refer its case to the Parity Committee.j) This section does not apply to persons under 16 years of age in a public relief institution governed by the Quebec Public Clarities Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 187).XL Special provisions: a) Notwithstanding the .provisions of the decree, in the establishments where the regular hours constituting a normal working week are fewer than those given in section IV, \"a\" and \"6\" and where the normal wage schedule is actually higher than the minimum established by the decree, the said normal working week shall be maintained and the said higher wage schedule shall continue to apply to all actual employees of such establishments until the expiration of the decree.6) No piece-work may be performed in any shop except as provided for hand engravers on copper under item iii, paragraph \"4\", subsection \"b\", section II.c) Home work is prohibited.No employer has the right of giving to anyone work to be done at home; likewise, an employee must not accept such work.-» XII.If new machines or new processes come in use during the existence of the decree, the scale of wages and the conditions applying to those machines or processes will be determined by an amendment to the decree, subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.88, No.7 655 XTTT.Gîte et couvert: Lorsque, suivant une XIII.Board and lodging: When, by agree- convention entre l'employeur et le salarié, le ment between the employer and the employee, logement, les repas ou la pension complète sont lodging or board or both are provided by the fournis par l'employeur, celui-ci ne peut déduire employer, the latter may not deduct more than plus\" que les prix suivants du salaire du salarié: the following rates from the wages earned: Par repas $0.20 Pour le logement par semaine $1.50 Pour repas de la semaine $4.00 Logement et pension par semaine $5.00 Pour le logement\t par jour\tPer meal $0.25\t$0.20 Logement\tLodging et pension\tper week par mois\t $20.00\t$1.50 Meals of the week $4.00 Board and lodging per week $5.00 For lodging per day $0.25 Board and lodging per month $20.00 XIV.Paiement des salaires: Les salaires doivent être payés en argent chaque semaine dans tous les établissements assujettis au décret.Ce salaire doit être remis à chaque salarié dans une enveloppe scellée, sur laquelle sont inscrits son nom, son numéro de matricule, la date de la semaine de travail, le nombre d'heures accomplies, le taux de salaire à l'heure, le montant d'argent contenu dans l'enveloppe, laquelle doit être initialée par la personne qui a fait la paye.XV.Lors de la ratification de la présente convention, le Comité Paritaire existant, formé pour surveiller l'application du décret antérieur dans la juridiction territoriale déterminée par le présent décret, demeure en fonction et surveille la mise à exécution du décret jusqu'à ce que les parties contractantes aient formé un nouveau Comité.Ce nouveau comité succède à l'ancien et est investi de tous les actifs et droits dudit Comité; il assume également toutes les dettes de l'ancien comité, en vertu dudit décret antérieur.XIV.Payment of wages: Wages shall be paid every week, in cash, in all establishments governed by the present decree.The pay shall be given to each employee in a sealed envelope on which shall be written: his name, his registration number, the date of the week of labour, the number of hours worked, the wage rate per hour, the amount contained in the envelope which shall be initialed by the pay clerk.XV.Upon the coming into force of the present agreement, the existing Parity Committee formed to administer the former decree in the territorial jurisdiction determined by the present decree, remains in office and supervises the carraying out of the decree until the contracting parties form a new committee.This new committee shall succeed the former one and be vested with all its assets and rights; it shall also assume all the liabilities of the former.Parity Committee under the said former decree.XVI.Le présent décret abroge le décret numéro 1675 du 10 décembre 1948 et tous ses amendements.XVII.Durée du décret: Le décret sera valable à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1951 inclusivement.Il se renouvelle automatiquement d'année an année,-par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de 60 jours ni moins de trente (30) jours avant l'expiration du terme original ou avant l'expiration de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.Les parties contractantes ont convenu d'être liées par les dispositions du décret, à compter du 1er janvier 1951.A.MORISSET, 29514-o Greffier du Conseil Exécutif.XVI.The present decree repeals the decree number 1675 of December 10, 1948, and all its amendments.XVII.Duration of the decree: The present decree comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remains in full effect until December 31, 1951, inclusively.It then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary, within the period extending from the 60th to the 30th day before the expiration of the original term or before the expiration of any subsequent year.Such a notice must also be forwarded to the Minister of Labour.The contracting parties have agreed to be bound by the provisions of the decree as from January 1, 1951.A.MORISSET, 29514-0 Clerk of the Executive Council.Avis divers Miscellaneous Nqtices Canada, Province de Québec, District de Canada, Province of Quebec, District of Chicoutimi.Chicoutimi Avis d'érection en municipalité de ville Notice of erection into a town municipality A qui~de droit: To whom it may concern: Le Conseil de la municipalité du village de The Council of the municipality of the village Sainte-Anne de Chicoutimi, comté de Chicoutimi, of Sainte-Anne de Chicoutimi, county of Chi- province de Québec, donne par les présentes avis coutimi, county of Chicoutimi, Province of Que- de son intention d'ériger la municipalité du village bec, hereby gives notice of its intention to erect 656 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 88, N° 7 de Sainte-Anne de Chicoutimi en Municipalité de Ville.a) Le nom de municipalité projetée sera \"La Ville de Chicoutimi-Nord\"; b) Le territoire de ladite municipalité de la Ville de Chicoutimi-Nord comprendra: \"Les lots un a six inclusivement du premier rang est du plan officiel du village de Sainte-Anne de Chicoutimi; et des lots N° 7 à 143 inclusivement du premier rang ouest du plan officiel du village de Sainte-Anne de Chicoutimi; des lots N° 9-A, 10-A, 10-B, 10-C, 1Û-D et 10-E du premier rang ouest du canton Tremblay faisant maintenant partie du village de Sainte-Anne de Chicoutimi.Et elle est bornée comme suit: au nord par les terres du rang 3 du Canton Tremblay, au sud par la Rivière Saguenay, au nord-est et sud-est par le lot N° 2 du premier rang Est du Canton Tremblay et à l'ouest par les lots Nos 11-A et 11-B du premier rang Ouest du Canton Tremblay, au nord-ouest par le lot 32 du deuxième rang ouest du canton Tremblay\".c) Le recensement de la population du village de Sainte-Anne de Chicoutimi s'établit 3,963 (trois mille neuf cent soixante-trois) âmes, tel que constaté par un recensment ordonné par le conseil, le 2 janvier 1951.d) L'érection de la municipalité de la ville de Chicoutimi-Nord se fera sous l'empire de la Loi des Cités et Villes, Ch 233 S.R.P.Q.1941 et ses amendements.Et le présent avis est publié à toutes fins que de droit.Chicoutimi, le 26 janvier 1951.Le Secrétaire-trésorier de la Municipalité du Village de Sainte-Anne de Chicoutimi, 29359-5-4-0 DAVID BOUCHER.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association des Contremaîtres et Surintendants du District de Hull\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 5 février 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Hull, comté de Hull.Le Sous-secrétaire de la Province, 29465-o * JEAN BRUCHÉSI.M & A Sheet Metal Works Ltd.Extrait des Minutes d'une assemblée générale annuelle des actionnaires de \"M & A.Sheet Metal Works Ltd.\", tenue le 1er mai 1950: \"Sur motion dûment faite, secondée et unanimement proposée, il est décrété que le règlement 29 est abrogé et remplacé par le règlement numéro 30 lequel se lit comme suit: Règlement N° 80.1.Le nombre des directeur de la Compagnie est par les présentes réduit de 4 à 3 et le bureau des directeurs de la compagnie sera dorénavant composé de trois directeurs.\" Vraie copie.Certifié conforme ce 30 janvier 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29470-o ARIEN LAMOUREUX.the Village Municipality of Sainte-Anne de Chicoutimi into a Town Municipality.o) The name of the proposed municipality to be: \"The Town of Chicoutimi-Nord\"; b) The territory of the said municipality of the Town of Chicoutimi-Nord to consist of: \"Lots one to six inclusively of the First East range on the official plan for the village of Sainte-Anne de Chicoutimi; and lots 7 to 143 inclusively of the First West range on the official plan for the Village of Sainte-Anne de Chicoutimi; lost Nos.9-A, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D and 10-E of the First West range of the township Tremblay now forming part of the village of Sainte-Anne de Chicoutimi.And is bounded as follows: On the north by the lands of Range 3 of the Township Tremblay, on the south by the Saguenay river, on the northeast and southeast by lot No.2 of the First East range of the Township Tremblay and on the west by lots Nos.11-A and 11-B of the first west range of the township Tremblay, on the ncrthwest by lot 32 of the Second West range of the Township Tremblay.\" c) The census of the popidation of the vill ge of Sainte-Anne de Chicoutimi is establis e 1 at 3,963 (three thousand nine hundred and sixty-three) souls, as ascertained by the census ordered by the Council on the 2nd of Januarv, 1951.d) The erection of the municipality of the Town of Chicoutimi-Nord shall be made under the provisions of the Cities and Towns Act, Chapter 233, R.S.Q., 1941, and its amendments.And the present notice is published for all legal purposes.Chicoutimi, January 26, 1951.DAVID BOUCHER, Secretary-Treasurer oft he Municipality of the village of Sainte-Anne de Chicoutimi.29359-5-4 NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the \u2022 name of \"Association des Contremaîtres et Surintendants du District de Hull\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on February 5, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Hull, county of Hull.JEAN BRUCHÉSI, 29465 Under Secretary of the Province.M & A Sheet Metal Works Ltd.Excerpt from the minutes of a annual genral meeting of the shareholders of the \"M & A Sheet Metal Works Ltd.\", held on May 1st, 1950: \"Upon its being duly moved, seconded, and unanimously proposed, it is enacted that By-law number 29 be repealed and replaced by By-law number 30, the same reading as follows : By-law No.80.1.The number of directors of the company is hereby reduced from 4 to 3 and the board of directors of the company shall henceforth, be composed of three directors.\" True copy.Certified correct, January 30, 1951.ADRIEN LAMOUREUX, 29470 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 657 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Club d'Hiver Saint-Martin de Tours\", en date du 15 janvier 1951, dont le siège social est situé à Saint-Martin, comté de Beauce, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 1er février 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29466-0 JEAN BRUCHÉSI.Province de Québec Municipalité des Cantons Unis de Fiedmont & Barraute Comté d'Aditidi Avis est par les présentes donné par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité des cantons unis de Fiedmont & Barraute, comté d'Abitibi, que le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé en date du 4 janvier^ 1951, suivant un rapport du Comité de l'honorable Conseil exécutif, le changement du nom de la municipalité des Cantons Unis de Fiedmont & Barraute en celui de \"Municipalité de Fiedmont & Barraute\" comté d'Abitibi.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code Municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Barraute, 22 janvier 1951.Le Maire, WILFRID LAROSE.Le Secrétaire-trésorier, 29467-0 JEAN-LOUIS ROMPRE.Gidko Corporation Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs de la compagnie \"Que les directeurs de la compagnie soit augmenté de trois (3) à quatre (4).\" Vraie copie certifiée du règlement décrété par les directeurs de la compagnie à une assemblée tenue le 15 décembre 1959, et approuvé, confirmé et ratifié à une assemblée des actionnaires de la compagnie tenue le 15 décembre 1950.Le Secrétaire, 29468 , R.KOCH.Avis est donné que, par nouvelle procuration exécutée le 22 janvier 1951, Frederic Leslie Parsons, de la cité de Montréal, a été nommé agent principal de \"Joseph Constantine Steamship Line Limited\" pour la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q.1941, chapitre 279, à compter du 28.février 1951, et qu'à compter de ladite date (28 février 1951), le bureau principal de ladite corporation sera dans l'édifice Sun Life, en ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 8 février 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29469 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Club d'Hiver St-Martin de Tours\", under date the 15th day of January, 1951, whereof the head office is at Saint Martin, county of Beauce, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29466 Under Secretary of the Province.Province of Quebec.Municipality op the United Townships of Fiedmont & Barraute County of Abitibi Notice is hereby given by the Mayor and the Secretary-Treasurer of the Municipality of the United Townships of Fiedmont & Barraute, county of Abitibi, that the Lieutenant-Governor in Council has approved, under date the 4th day of January, 1951, following a report from the Committee of the Honourable the Executive Council, the change of name of the Municipality of the United Townships of Fiedmont & Barraute into that of the \"Municipality of Fiedmont & Barraute\", county of Abitibi.Pursuant to the provisions of Article 48 of the Municipal Code, this change of name comes into force as from the date of the publication of the present notice in the Quebec Official Gazette.Barraute, January 22, 1950.WILFRID LAROSE, Mayor.JEAN LOUIS ROMPRE, 29467 Secretary-Treasurer.Gidko Corporation By-law increasing the number of directors of the company \"That the Directors of the Company be increased from three (3) to four (4).\" Certified true copy of By-law enacted by the directors of the company at a meeting held on the 15th day of December, 1950, and approved, confirmed and ratified at a meeting of the shareholders of the company, held on the 15th day of December, 1950.R.KOCH, 29468-0 Secretary.Notice is hereby given that, by new power of attorney executed on January 22nd, 1951, Frederic Leslie Parsons of the City of Montreal, was appointed Chief Agent of \"Joseph Constantine Steamship Line Limited\" for the Province of Quebec under the provisions of the Extra-Provincial Companies' Act, R.S.Q.1941, cliaptcr 279, as and from the 28th February, 1951, and that as and from the said date (February 28th 1941), the principal office of the said Corporation will be at Sun Life Building, in the said City of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of February, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29469-o Under-Secretary of the Province. 658 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 88, N° 7 Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.Règlement N° 5 Un règlement concernant la distribution de l'actif de \"Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.\" 1.Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de liquider ses affaires; 2.Attendu que la compagnie n'a pas de dettes ou obligations; 3.En conséquence, qu'il soit décrété, comme un règlement de \"Retail Sales Promotion (Que-bec) Ltd.\" ce qui suit: o) Que la compagnie soit et elle est, par les présentes autorisée à disposer de ses biens, distribuer son actif au pro rata entre ses actionnaires enregistrés au moment de ladite distribution, et subséquemment, pourvoir à la dissolution au moyen des procédures d'abandon de charte conformément à l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.b) Les directeurs et officiers sont, par les présentes, autorisés et dirigés à faire, signer et exécuter toutes choses, actes et documents nécessaires ou désirables à la bonne exécution du précédent.Décrété ce 30 novembre 1950.Le Président, A.D.CCSSABOOM.Le Secrétaire, * CLAUDE DUCHARME.Vraie copie certifiée du règlement N° 5 de \"Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.\" décrété à une assemblée des directeurs de ladite compagnie, tenue le 30 novembre 1950, et sanctionné et confirmé par les actionnaires à une assemblée générale spéciale des actionnaires dûment convoquée et tenue le 30 novembre 1950.(Sceau) Le Secrétaire.29471 CLAUDE DUCHARME.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le 31 janvier 1951, le changement de nom de l'\"Association des Employés du Bas Façonné de Canadian Silk Products\" en celui de \"Association des Employés du Bas Façonné de Orient Hosiery Sherbrooke Inc.\" \u2014 \"The Full Fashioned Hosiery Workers' Association of Orient Hosiery Sherbrooke Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles que modifiées par 10 George VI, chapitre 20.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 2 février 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29472-0 JEAN BRUCHÉSI.Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.By-law No.5 Being a By-law respecting the distribution of the assets of \"Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.\" 1.Whereas the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs; 2.Whereas the Company has no debts or obligations; 3.Therefore be it enacted as a By-law of \"Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.\" that: a) The Company be and is hereby authorized to dispose of its property, distribute its assets rateably among its shareholders of records at the time of said distribution and subsequently to proceed to dissolution by way of surrender of Charter proceedings under Section 26 of the Qrrebcc Companies' Act.b) The Directors and officers are hereby authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desira-able fot the due carrying out of the foregoing.Enacted this 30th day of November, 1950.A.D.COSSABOOM, President CLAUDE DUCHARME, Secretary.Certified to be a true copy of By-law No.5\"of \"Retail Sales Promotion (Quebec) Ltd.\", enacted at a meeting of the Directors of the said Company, held on the 30th day of November 1950, and sanctioned and confirmed by the shareholder's at a special general meeting of the shareholders duly called and held on the 30th day of November, 1950.(Seal) CLAUDE DUCHARME, 29471-0 Secretary.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of January 31, 1951, has authorized the change of name of the \"Association des Employés du Bas Façonné de Canadian Silk Products\", to that of \"Association des Employés du Bas Façonné de Orient Hosiery Sherbrooke Inc.\" \u2014 \"The Full Fashioned Hosiery Workers' Association of Orient Hosiery Sherbrooke Inc.\", and such pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as amended by 10 George VI, chapter 20.Given at the office of the Provincial Secretary, February 2, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29472 Under Secretary of the Province.Sterling Sales & Salvage Co.Règlement spécial N° 55 (pour modifier le règlement N° 3) (en augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de trois à quatre) \"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction de quatre directeurs dont chacun, au moment de son élection et Sterling Sales & Salvage Co.Special by-law No.65 (to amend By-law No.3) (by increasing the number of directors of the Company from three to four) \"The affairs of the Company shall be managed by a Board of Four Directors, each of whom at the time of his election, and throughout the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.83, No.7 659 pendant toute la durée de son terme, sera un actionnaire de la compagnie au montant d'au moins une action et sans arrérages relativement à tout appel sur icelle.\" Vraie copie certifiée du règlement spécial N° 55 passé à une assemblée des directeurs tenue le 24 novembre 1950, et approuvé par les actionnaires à une assemblée tenue le même jour.Le Secrétaire, 29482 JOSEPH GOLDBERG.term of his office shall be a shareholder in the Company to the amount of at least one share and not in arrears in respect to any call thereon.\" Certified true Copy of special by-law No.55 passed at a meeting of the Board of Directors held on the 24th day of November, 1950 and approved by the shareholders at a meeting held on the same dav.JOSEPH GOLDBERG, 29482-0 Secretary.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat d'Aqueduc de Notre Dame de la Paix\", en date du 9 septembre 1948, dont le siège social est situé à Notre-Dame de la Paix, comté de Papineau, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 15 novembre 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 29473-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat d'Aqueduc de Notre Dame de la Paix\", under date the ninth day of September, 1948, whereof the head office is at Notre-Dame de la Paix, county of Papineau, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fifteenth day of November, 1950.JEAN BRUCHÉSI, 29473 Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 9 février 1951, les règlements 1 à 14 inclusivement de \"La Jeunesse Agricole Catholique Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la province le 12 février 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29484-o JEAN BRUCHÉSI.Avis es! d nné que, sur la recommandation de 1'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 24 janvier 1951, les règlements généraux de \"Les Concerts Sym-phoniques de Montréal\", tels qu'approuvés aux assemblées tenues les 23 juin 1949 et 26 septembre 1950, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 26 janvier 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29485-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the by-laws 1 to 14 inclusively of \"La Jeunesse Agri-cole Catholique Inc.\", were approved by the Honourable the Provincial Secretary on the 9th day of February, 1951, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q., 1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary, this twelfth day of February, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29484 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, tlie general by-laws of \"Les Concerts Symphoniqucs de Montréal\", as approved at meetings held on the 23rd of June, 1949, and 26th of September, 1950, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on the 24th of January, 1951, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q., 1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of January, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29485 Under Secretary of the Province.Montreal Securities Corporation Montreal Securities Corporation Règlement spécial \"B\" Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs et modifier le règlement trois en conséquence.Le nombre des directeurs de cette compagnie est, par les présentes, augmenté de trois à quatre et l'article I du règlement trois est, par les présentes, modifié en y rayant le mot \"trois\" et en y substituant le mot \"quatre\".Vraie copie certifiée.Daté en la cité de Montréal, P.Q., le 9 février 1951.[Sceau] Le Secrétaire, 29486 V.H.CHISLETT.Special By-law \"B\" A By-law to increase the number of Directors, and to amend By-law Three accordingly.The number of Directors of this company is hereby increased from Three to Four and Article I of By-law Three is hereby amended by deleting therefrom the word \" Three\" and by substituting therefor the word \"Four\".Certified true copy: Dated at the city of Montreal, P.Q;, this ninth day of February, 1951.[Seal] V.H.CHISLETT, 29486-o Secretary. 660 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 Chambly Power Corporation Changement de situation du siège social \u2014 Règlement: Il est résolu : Que le suivant soit et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de cette compagnie: Attendu que par lettres patentes de la province de Québec datées du 2 août 1926, constituant la compagnie \"Chambly Power Corporation\" en corporation, il est stipulé que le bureau principal de la compagnie est situé au Canton Chambly, comté de Chambly, province de Québec; et Attendu que le siège social de la compagnie a été situé auparavant au susdit canton Chambly; et .t , .Attendu qu'il est maintenant jugé nécessaire de changer la situation du siège social de la compagnie à la cité de Montréal; Que, étant en vigueur immédiatement, le siège social de la compagnie soit transporté du Canton Chambly, comté de Chambly à la cité de Montréal, district de Montréal, province de Québec.Je, Robert W.R.MacGrcgor, secrétaire-conjoint de la compagnie \"Chambly Power Corporation\", certifie, par les présentes, que le précédent est copie conforme et exacte d'un règlement décrété par le bureau ele direction de ladite compagnie à l'assemblée tenue mardi, le 2 janvier 1951, et ratifié à l'unanimité à une assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite compagnie tenue le dix janvier 1951, à laquelle les détenteurs de 99.9% des actions émises et en cours de ladite compagnie étaient présentes ou représentées par procuration.# t t Le Secrétaire-conjoint, 29487 .R.W.R.MacGREGOR.The Imperial Trust Company AVIS Avis est, par les présentes, donné que le capital-actions de la compagnie \"The Imperial Trust Company\" a été augmenté à cinq millions de dollars (85,000,000) divisé en cinquante mille (50,000) actions d'une valeur au pair de cent dollars ($100) chacune.Montréal, P.Q., 10 février 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29491-7-3 CAMPBELL SHAW.Hector Investments Limited Sommaire du règlement \"C*\" Attendu que la compagnie \"Hector Investments Limited\" a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de liquider ses affaires et n'a pas de dettes ou obligations qui n'ont pas été pourvues ou protégées, il a été, en conséquence, décrété que l'actif de la compagnie soit distribué entre ses actionnaires.Décrété le 12 février 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29192 L.G.PROCTOR.Chambly Power Corporation Change of location of Head Office \u2014 By-law: Resolved : That the following be and it is hereby enacted as a By-law of this company: Whereas under letters patent of the Province of Quebec dated August 2nd, 1926, incorporating \"Chambly Power Corporation\", the chief place of business of the company is stipulated to be Chambly Canton, county of Chambly, Province of Quebec; and Whereas the head office of the company has heretofore been located in Chambly Canton aforesaid; and Whereas it is now deemed expedient to change the location of the head office of the company to the city of Montreal; That, effectively immediately, the head office of the company be changed from Chambly Canton, County of Chambly, to the City of Montreal, District of Montreal, Province of Quebec.I, Robert W.R.MacGregor, Joint Secretary of \"Chambly Power Corporation\", hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of a By-law enacted by the Board of Directors of the said Company at meeting held Tuesday, January 2nd, 1951, and ratified unanimously at a special general meeting of the shareholders of the said company, held on the tenth day of January, 1951, at which were present or represented by proxy 99.9% of the issued and outstanding shares of the said company.R.W.R.MacGREGOR, 29487-0 Joint Secretary.The Imperial Trust Company NOTICE Notice is hereby given that the capital stock of \"The Imperial Trust Company\" has been increased to Five million dollars ($5,000,000) divided into Fifty thousand (50,000) shares of the par value of One hundred dollars ($100.) each.Montreal, P.Q., February 10th 1951.CAMPBELL SHAW, 29491-7-3-o Secretary-Treasurer.Hector Investments Limited Summary of By-Law \"C\" Whereas \"Hector Investments Limited\" has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs and has no debts or obligations that have not been provided for or protected it was therefore enacted that the assets of the Company be distributed among its shareholders.Enacted this 12th day of February, 1951.L.G.PROCTOR, 29492-0 Secretary-Treasurer.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes elonné que la ville St-Michel s'adressera à la Législature de la Province, à sa présente session, en vue de faire adopter une loi amendant sa charte, la loi 5 George V,chap.109 et amendements, pour accorder une indemnité annuelle à son maire et à ses échevins, pour annexer certains territoires PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of Saint-Michel will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present ses sion, for the adoption of an Act amending its charter, Act 5 George V, cliapter 109 and amendments, to provide an annual indemnity for the mayor and aldermen, to annex certain territories ac- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.88, No.7 661 actuellement compris dans la ville de Saint-Léonard de Port-Maurice, pour accroître et modifier les pouvoirs de la Ville de réglementer la construction, et pour d'autres matières.Ville Saint-Michel, le 12ième jour de février 1951.Le Procureur de la Ville Saint-Michel, GASTON POULIOT.29494-7-4-o 265 ouest, rue Craig.Montréal.Manicouagan Power Company Règlement N° I de \"Manicouagan Power Company\" Un règlement pour amender les règlements généraux de la compagnie en augmentant le nombre de ses directeurs de 9 à 11.Qu'il soit décrété par les directeurs de la compagnie \"Manicouagan Power Company\" comme un règlement de ladite compagnie ce qui suit: Le règlement N° 3 de la compagnie est, par les présentes, révoqué et le suivant y est substitué: \"3.Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction composé de onze personnes, dont chacune sera un actionnaire de la compagnie détenant au moins une action de son capital.\" Passé par les directeurs et approuvé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée le 25 janvier A.D.1951 pour considérer le règlement.Le Président, ARTHUR SCHMON.L'Assistant-secrétaire, 29507 T.E.SIEGERMAN.Steel Briqueting Corporation Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois à quatre.Vraie copie certifiée du règlement décrété par les directeurs de la compagnie le 4, janvier 1951, et sanctionné et confirmé à l'unanimité à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie dûment convoquée pour le considérer et tenue le 4 janvier 1951.Le Secrétaire, 29508 FRED L.HARFORD.Quebec Brewers Association L'Association des Brasseries de la Porvince de Québec Extrait du règlement \"D\" de l'association ci-dessus nommée concernant une augmentation de son bureau de direction à onze directeurs: \"Les affaires de la corporation seront administrées par un bureau de direction de onze (11) directeurs.\" Copie conforme certifiée.Montréal, 23 janvier 1951.Le Secrétaire, 29516 H.GEO.GONTHLER.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 12 février 1951, le règelment \"D\" amendant les règlements Vn et XIV de \"Quebec Brewers Association\u2014\" tually situated in the Town of Saint-Leonard de Port-Maurice; to increase and modify the Town's poser to make building by laws, andfor other purposes.Town of Saint-Michel, the 12th day of February 1951.GASTON POULIOT, 265 Craig St.West, Montreal.29494-7-4-0 Attorney for the Town of St-Michel.Manicouagan Power Company By-Law No.I of \"Manicouagan Power Company\" Being a by-law to amend the general by-laws of the Company by increasing the number of Directors thereof from 9 to 11 Be it enacted by the Directors of Manicouagan Power Company as a By-law of the said Company as follows: By-law No.3 of the Company is hereby repealed and the following substituted therefor: \"3.The affairs of the Company shill be managed by a Board of Directors to consist of eleven persons, each of whom shall be a Shareholder in the Company, holding at least one share of stock thereof.\" Passed by the Directors and approved by the vote of at least two-thirds in value of the shares represented by the Shareholders present at a Special General Meeting called on the 25th day of Januray, A.D.,1951, for considering the by-law.ARTHUR SCHMON, ' President.T.E.SIEGERMAN, 29507-o Assistant-secretary.Steel Briqueting Corporation By-law Increasing the number of Directors That the number of Directors of the Company be increased from three to four.Certified true copy of By-law enactetl by the Directors of the Company on January 4th ,1951, and sanctioned and confirmed unanimously at a Special General Meeting of the Shareholders of the Company duly called to consider the same, and held on January 4th, 1951.FRED L.HARFORD, 29598-o \u2022 Secretary.Quebec Brewers Association l'associafion des brasseries de la province de Québec Extract of By-Law \"D\" of the above named association concerning an increase in the directorate thereof to eleven directors: \"The affairs of the Corporation shall be managed by a board of eleven (11) Directors.\" Certified an exact copy, Montreal, January 23rd, 1941.H.GEO.GONTHIER, 29516-0 Secretary.Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-law \"D\" amending by-laws VII and XIV of the \"Quebec Brewers Association\" \u2014 \"L'Association des Bras-scries de la Province de Québec\", fias been approv- 662 GAZETTE OFFICIELLE DE QUtuBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 \"L'Association des Brasseries de la Province de Quebec\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec, S.R.Q.1951, chapitre 276.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 15 février 1951.Le Sous-secrétaire de la province, 29517-0 JEAN BRUCHÉSI.ed by the Honourable the Provincial Secretary on the 12th day of February, 1951, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Compa nies Act, R.S.Q., 1941, chapter 176.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of February, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29517 Under Secretary of the Province.Département des Affaires municipales A qui les présentes peuvent concerner: Avis est par les présentes donné que, par l'arrêté en conseil N° 135, du 8 février 1951, et conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi des cités et villes, il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement N° 292 du conseil de la cité de M agog, et de décréter que, à compter de la date de la publication du présent avis, le territoire décrit comme ci-dessous, formant actuellement partie de la municipalité du canton Magog est annexé à la cité de Magog: Le territoire situé dans le canton de Magog comprenant, en référence au cadastre officiel pour le dit canton, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et à venir, ainsi que les chemins, rues, ruelles, emprises de chemin de fer, rivières, cours d'eau, ou partie d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant du point d'intersection du prolongement de la ligne sud du lot 4c du rang XVII (Bolton) avec l'axe de la Rivièrc-aux-Cerises; de là, passant par les lignes et démarcations suivantes en continuité les unes des autres:\u2014 le dit axe de la Rivières-aux-Cerises jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 4a rang XVII (Bolton); le dit prolongement, la dite ligne nord du lot 4a et la ligne nord du lot 4b, rangXVII (Bolton); la ligne nord du lot 4h, rang XIX (Bolton); la ligne nord des lots4a,4b,et 4d, rang XIX (Bolton);-la ligne separative des rangs XIX et XX (Bolton); la ligne nord du lot 5, rang XX (Bolton); la ligne-separative des rangs XX et XXI (Bolton) prolongée jusqu'à l'axe de la rivière Magog; le dit axe de la rivière Magog en remontant son cours jusqu'à un point vis-à-vis de l'embouchure d'un fossé sur la rive droite ou rive sud de la rivière Magog, la dite embouchure étant à une distance perpendiculaire de 1245 pieds'plus ou moins au nord de la ligne sud du lot 20, rang XI (Hatley); une ligne dans la rivière Magog jusqu'à la dite embouchure d'un fossé; une ligne suivant le milieu du fossé dans la direction astronomique S.37' 15'E., sur une distance de 1482 pieds, plus ou moins; une autre ligne suivant le milieu du même fossé dans la direction astronomique S.40' 30'E., sur une distance de 242 pieds plus ou moins, jusqu'au côté nord du chemin de Katevale à Magog; le dit côté nord du dit chemin en allant vers l'ouest jusqu'à son point d'intersection avec la ligne sud du lot 20, rang XI (Hatley); la dite ligne sud du lot 20, rang XI (Hatley) jusqu'aux limites actuelles de la ville de Magog; de là suivant les limites actuelles de la ville de Magog en passant par la dite ligne sud du lot 20, rang XI Hatley); une ligne joignant le coin ouest du lot 20, rang XI (Hatley) au coin sud-ouest du lot 6, rang XIX (Bolton) ; la ligne ouest des lots 6, 5e et 5c, rang XIX (Bolton); la ligne sud des lots 4g, 4c, 4b et 4a, rang XVIII (Bolton) et enfin, la ligne sud du lot 4c,-'rang XVII (Bolton) et son pro- Department of Municipal Affairs TO whom it may concern : Notice is hereby given that, by Order in Council No.135, of the 8th of February, 1951, and pursuant to the provisions of section 43 of the Cities and Towns Act, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve By-law No.292 of the Council of the city of Magog, and to enact that, as from the date of the publication of the present notice, the territory hereinafter described, forming actually part of the municipality of the Township of Magog is annexed to the city of Magog: The territory situate in the township of Magog, comprising, with reference to the official cadastre for the said township, the lots or parts of lots and their present and future sub livisions, and also the roads, streets, lanes, railway rights of way, rivers, watercourses, or parts of same, enclosed within the following boundaries, to wit: Starting from the point of intersection of the prolongation of the south line of lot 4c of range XVII (Bolton) with the axis of the \"Rivière-aux-Cerises\"; thence, passing by the following lines and demarcations successively: The said axis of the \"Rivière-aux-Cerises\" as far as the prolongation of the north line of lot -4a, range XVII (Bolton); the said prolongation, the said north line of lot 4a and the north line of lot 4b, range XVII (Bolton); the north line of lot 4h, range XVIII (Bolton); the north line of lots 4a, 4b and 4d, range XIX (Bolton); the division line of ranges XIX and XX (Bolton); the north line of lot 5, range XX (Bolton); the division line of ranges XX and XXI (Bolton) extended as far as the axis of the Magog river; the said axis of the Magog river upstream to a point facing the outlet of a drainage ditch on the right shore or south shore of the Magog river, the said outlet being at a perpendicular distance of 1245 feet, more or less, north of the south line of lot 20, range XI (Hatley) ; a line in the Magog river up to the said outlet of the drainage ditch; a.line following the middle of the ditch in a direction astronomically S.37' 15' E.for a distance of 1482 feet, more or less; another line following the middle of the same ditch in a direction astronomically S.40' 30'E.for a distance of 242 feet feet, more or less, up to the north side of the road from Katevale to Magog; the said north side of the said road running towards the west as far as the point of its intersection with the south line of lot 20, range XI (Hatley); the said south line of lot 20, range XI (Hatley) up to the actual limits of the town of Magog; thence following the actual limits of the town of Magog and passing by the said south line of lot 20, range XI (Hatley) ; a line joining the west corner of lot -20, range XI (Hatley) to the southwest corner of lot 6, range XIX (Bolton); the west line of lots 6, 5e and 5c, range XIX (Bolton); the south line of lots 4g, 4c, 4b and 4a, range XVTII (Bolton and finally, the south line of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1951, Vol.88, No.7 c63 longement jusqu'à son intersection avec l'axe de la Rivière-aux-Cerises, point de départ.Le Ministre des Affaires Municipales, 29474-0 BONA DUSSAULT.lot 4c, range XVII (Bolton) and its prolongation as far as its intersection with the axis of the \"Rivière-aux-Cerises\", the starting point.BONA DUSSAULT, 29474 Minister of Municipal Affairs.Département de l'Agriculture Avis est par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse de Ste-Blandine, le cercle agricole de la paroisse Ste-Céjile du Bic et le cercle agricole de la mission de St-Nareis32, tous trois dans le comté de Rimouski, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cer.les agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conf >rmSment aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 13 février 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 29503-o R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse de Ste-Jeanne-de-Chantal de l'Ile Perrot, le 'ercie agricole de la parusse Ste-Mag leleine de Bigau 1 et le cercle ajri oie de la paroisse de St-ML-hel de Vau Ireuil, ayant négligé, pendant deux ans, de se conforme.' aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément arrx dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 13 février 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 29503-o R.TRÉPANIER.Department of Agriculture Notice is hereby given that the Farmers' Club of the parish of Ste-Blandine, the Fanners' Club of the parish of Ste.Cécile du Bic and the Farmers' Club of the Mission of St-Narcisse, all three in the county of Rimouski, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmors' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118) the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, Februarv 13, 1951.\u2022 R.TRÉPANIER, 29503 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' club of the parish of Ste-Jcanne-de-Chantal de l'Ile Perrot, the Farmers' club of the parish of Ste-Mag-deleine de Ri;rru 1 and t'ie Farmers' club of the parish of St-Michel de Vaudreuil, all three in the county of Vaudreuil, having neglected for two ycxs to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q., 1941, chapter 118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, February 13, 1951.R.TRÉPANIER, 29503 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la * Province de Québec \u2022 Ordonnance N° 1-50A Extrait des procès verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec.Séance du jeudi, 8 février 1951, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à -Québec, à 10 heures de l'avant-midi.Présen's: MM.Omer E.Milot, président; Joseph Hébert, Adrien Angers, commissaires; Alnhonse Savoie, secrétaire; C.A.Gamache, c.r., aviseur légal et Roland Camirand, inspecteur général de3 Produits 1 itiers.Après avir considéré le3 conditions de l'Industrie lai.ière dans la région de Montréal, La Commission décqète ce qui suit: 1° L'arti le 2° de l'ordonnance N° 1-50, publiée dans la Gazette officielle de Québec du 28 octobre 1950, est abrogé et remplacé par le suivant: \"2° La région de Montréal comprend les muni ipalités suivantes, situées dans le district judi.iaire de Montréal, savoir: la cité de Montréal, la cité d'Outremont, la cité de Westmount, la ville de Montréal-Ouest, la cité de Verdun, la cité de Lachine, la cité de Longueuil, la cité de Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.1-50A Excerpts from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Thursday, February 8th, 1951, held in the office of the Dairy Industry Commission in Quebec, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Omer E.Milot, President; Joseph Hébert, Adrien Angers, Commissioners; Alphonse Savoie, Secretary; C.A.Gamache, K.C.Legal Adviser and Roland Camirand, Inspector General of Dairy Products.Considering the conditions of the dairy industry within the region of Montreal, It is enacted as follows: 1° Article 2.of Order No.1-50, published in the Quebec Official Gazette of October 28th, 1950, is deleted and replaced by the following: \"2.The region of Montreal includes the following municipalities situated in the judicial district of Montreal, namely: the city of'Montreal, the city of Outremont, the city of Westmount, the town of Montreal-West, the city of Verdun, the city of Lachine, the city of Longueuil, the 664 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 Saint-Lambert, la ville de Dorval, la ville de Pointe-Claire, la ville de Montréal-Est, la ville de Mont-Royal, a ville de Hampstead, la municipalité du village de la Côte Saint-Luc, la ville de Saint-Laurent, la ville de Saint-Michel, la ville de Montréal-Nord, la ville de Saint-Pierre, la ville de Lasalle, la ville de Greenfield Paik, la ville de Montréal-Sud,' la ville de Pointe-aux-Trembles, le Port de Montréal, la ville de Beaconsfield, la ville de Baie d'Urfé, la ville de Sainte-Anne de Belleyue, la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse, la ville Jacques-Cartier, la ville LeMoyne, et la ville de Mackayville.\" La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Signé: MM.Cmfr E.Milot, président, Joseph Hébert, commissaire, Adrien Angers, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.29515-o city of Saint-Lambert, the town of Dorval, the town of Pointe-Claire, the town of Montreal-East, the town of Mount Royal, the town of Hampstead, the municipality of the village of Côte Saint-Luc, the town of Saint-Laurent, the town \u2022 of Saint-Michel, the town of Montreal-North, the town of Saint-Pierre, the town of Lasalle, the town of Greenfield Park, the town Montreal-South, the town of Pointe-aux-Trembles, the Harbour of Montreal, the town of Beaconsfield, the town of Baie d'Urfé, the town of Sainte-Anne de Bel le vue, the parish of Notre-Dame-de-Liesse, the town of Jacques-Cartier, the town of LeMoyne and the town of Mackayville.\" The present Order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Signed : Messrs.Omer E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary; 29515-o Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel du Canton de Rousseau division d'enregistrement de F Abitibi.Avis est par la présente donné que dans le Rang VII les lots 43-1 à 43-19 et 43-36 ont été annulés le 23 octobre dernier en vertu de l'article 2174 du Code civil.Québec, le 23 octobre 1950.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD, 29475-0 Sous-ministre.AVIS Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Constant Division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que les lots 256-6 à 256-94 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Quebec, le 31 janvier 1951.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD, 29475-0 Sous-Ministre.NOTICE Officiai Cadastre of the Township of Rousseau registration division of Abitibi.Notice is hereby given that in Range VII lots 43-1 to 43-19 and 43-36 have been cancelled on October 23rd last in virtue of Article 2174A of the civil Code.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, Quebec, October the 23rd, 1959.AVILA BÉDARD, 29475-o Deputy Minister.NOTICE * Official Cadastre of the Parish of Saint Constant Registration Division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 256-6 to 256-94 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 31st, 1951.Department of Lands and Forests, » Cadastral Bpanch, AVILA BÉDARD, 29475 o Deputy Minister.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BARREAU DU BAS SAINT-LAURENT \u2014 BAR OF THE LOWER SAINT LAWRENCE Candidat poor l'admission a l'étude du droit Candidate for the admission to the study of law Nom\tPrénom\t\tRésidence\tCollège \u2014\t\u2014\tAge\t\u2014\t Name\tSurname\t\tResidence\tCollege Dubé.\t\t25\tRivière-du-Loup .\tUniversité St-Joseph, N.B.\t\t\t\t Rimouski, le 3 février 1951.\u2014 Rimouski, February 3, 1951.Le Secrétaire du Barreau du Bas Saintr-Laurent, MAURICE TESSIER, 29418-6-2-0 Secretary of the Bar of the Lower Saint Lawrence. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 17th, 1961, Vol 88, No.7 665 Lettres patentes AVIS DE CORRECTION Commercial Equipment Inc.Avis est donné que l'avis publié dans la Gazette officielle de Québec, tome 82, No 45, du 11 novembre 1950, page 2822, sous le titre \"Commercial Equipment Limited\", est corrigé de la façon suivante: Partout où il apparaît dans ledit avis, le nom de la compagnie doit se lire: \"Commercial Equipment Inc.\" au lieu de Commercial Equipment Limited.Donné au bureau du Procureur général, ce neuf février 1951.L'Assistant-procureur général, 29504-o L.DÉSILETS.Lettres patentes supplémentaires Page Construction (Quebec) Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dé la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 décembre 1950, à la compagnie \"Page Construction (Québec) Limitée\", ratifiant son règlement N° 31 augmentant son capital-actions autorisé de $90,000 à $170,000 par la création de 800 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, comportant les mêmes droits, restrictions et privilèges que ceux attachés aux actions privilégiées déjà autorisées.Daté du bureau du Procureur général, le 19 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29505-o L.DÉSILETS.Regional Asphalte, Limitée Regional Asphalt, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 décembre 1950, à la compagnie \"Regional Asphalte, Limitée\" \u2014 \"Regional Asphalt, Limited\", ratifiant son règlement N° 33 augmentant son capital-actions autorisé de $20,000 à $520,000 par la création de 5,000 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 19 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29505-o L.DÉSILETS.The Charlevoix Sagucnay Navigation Company Limited La Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 décembre 1950, à la compagnie \"The Charlevoix Saguenay Naviga- Letters Patent NOTICE OF CORRECTION Commercial Equipment Inc.Notice is given that the notice published in the Quebec Official Gazette Volume 82, No.45, of November 11, 1950, page 2822, under the title \"Commercial Equipment Limited\", is corrected in the following manner: Wherever it appears in the said notice, the name of the company must read: \"Commercial Equipment Inc.\" instead of Commercial Equipment Limited.Given at the office of the Attorney General, this ninth of February, 1951.L.DÉSILETS, 29504 Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent Page Construction (Quebec) Limitée Notice is hereby given that under Part I*of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the nineteenth day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Page Construction (Quebec) Limitée\", ratifying its By-law No.31, increasing its authorized capital stock from $90,000 to $170,000, by the creation of 800 additional preferred shares of $100 each, subject to the same rights, restrictions and privileges as those attaching^to the already authorized preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1950.L.DÉSILETS, 29505 Deputy Attorney General.Regional Asphalte, Limitée Regional Asphalt, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the nineteenth day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Regional Asphalte, Limitée\"\u2014 \"Regional Asphalt, Limited\", ratifying its Bylaw No.33, increasing its authorized capital stock from $20,000 to $520,000 ,by the creation of 5,000 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictiond and privileges enumerated in the said By-law.Dated at Quebec, this nineteenth day of December, 1950.L.DESILETS, 29505 .Deputy Attorney General.The Charlevoix Sagucnay Navigation Company Limited La Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée ' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of December, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The Charlevoix Saguenay Navigation Company 666 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 février 1951, Tome 83, N° 7 tion Company Limited\" \u2014 \"La Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée\", ratifiant son règlement spécial \"B\": a) subdivisant les 400 actions privilégiées formant partie du capital autorisé de ladite compagnie en 4,000 actions privilégiées de 85 chacune; b) modifiant les dispositions des lettres patentes constituant la compagnie en corporation et, en particulier, les droits, restrictions et privilèges attachés à ses actions privilégiées; c) augmentant le capital autorisé de la compagnie par la création de 6,000 actions privilégiées additionnelles de 85 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement; d) fixant à pas moins que $15,000 le montant du capital avec lequel la compagnie exercera son commerce.Daté du bureau du Procureur général, le 21 décembre 1950.L'Assistant-procureur général, 29505 L.DÉSILETS.Limited\"\u2014
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.