Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 24 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1951-02-24, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 83, N° 8 689 Vol.83, No.8 \t\t ¥\t\t \t\t \t\t \t\t* Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel deja province (14Geo.VI,ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubushed by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 24 février 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion .est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, February 24th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will lie made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates here in below set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be pubilshed several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 690 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, février 1951, Tome 83, N° 8 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents bu annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de ietarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administra-tif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u20141-52 Lettres patentes Au Parasol Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quinze janvier 1951, constituant en corporation: Alexandre Tremblay, hôtelier, Yvonne Harvey, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Alexandre Tremblay, et Marie-Marthe Tremblay, commis, tous du village de la Rivièrc-du-Moulin, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Établir, exercer et exploiter le commerce de l'hôtellerie et de restaurant en general, sous le nom de \"Au Parasol Limitée\", avec un capital de $150,000, divisé en 600 actions privilégiées de SI00 chacune, et en 900 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 224, Boulevard Rivière-du-Moulin, village de la receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 wards.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u20141-52 Letters Patent Au Parasol Limitée Notice ¦ is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of January, 1951, incorporating: Alexandre Tremblay, hotel-keeper, Yvonne Harvey, housewife, wife separate as to property by marriage contract of said Alexandre Tremblay, and Marie Marthe Tremblay, clerk, all of the village of Rivière-du-Moulin, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To establish, carry on and operate generally a hotel and restaurant business, under the name of \"Au Parasol Limitée\", with a capital stock of $150,000, divided into 600 preferred shares of $100 each, and 900 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 224 Rivièrc-du-Moulin Boulevard, village of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February &lth, 1951, Vol.8$ No.8 691 Rivière-du-Moulin, district judiciaire de Clii-coutimi.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général 29520-o L.DÉSILETS.Autobus Métropolitains Ltée Metropolitan Busses Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1951, constituant en corporation: Clovis Dagenais, avocat, Lucienne Gagnon, comptable, Monique Couture et Flore-Annette Poirier, sténographes, tous quatre de la cité de Montréal, et Jeanne Senay, sténographe, de la cité de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des services de transport public ou privé, sous le nom de \"Autobus Métropolitains Ltée\" \u2014 \"Metropolitan Busses Ltd.\", Le capital-actions de la compagnie sera de 1,000 actions sans valeur nominale et de 1,000 actions privilégiées d'une valeur de 8100 chacune; et le montant du capital-actions arvec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $15,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Rivière-du-Moulin, judicial district of Chicou-timi.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520 Deputy Attorney General.Autobus Métropolitains Ltée Metropolitan Busses Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1951, incorporating: Clovis Dagenais, advocate, Lucienne Gagnon, accountant, Monique Couture and Flore Annette Poirier, stenographers, all four of the city of Montreal, and Jeanne Senay, stenographer, of the city of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes; To operate public or private transportation services, under the name of \"Autobus Métropolitains Ltée\" \u2014 \"Metropolitan Busses Ltd.\" The capital stock of the company will be 1,000 shares having no nominal value and 1,000 preferred shares of a value of S100 each; and the amount of capital stock with which the company will commence operations is $15,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Bar-Manitou Mines Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze novembre 1950, constituant en corporation: Pauline Cabana, Isabelle Lemay et Hélène Hussard, secrétaires, toutes des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais; Faire toute opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer,, sous le nom de \"Bar-Manitou Mines Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $3,000-000 divisé en 3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1950.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Best Lumber Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Bar-Manitou Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1950, incorporating: Pauline Cabana, Isabelle Lemay and Hélène Hussard, sacretaries, all of the City and judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals: Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Bar-Manitou Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a capital stock of $3,000,000.divided into 3,000,000 shares of $1.each.The shareholders will incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General .this fifteenth day of November, 1950.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Best Lumber Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 692 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Qéubec, U février 1951, Tome 88, N° 8 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf janvier 1951, constituant en corporation: Nathan Cotler, John Jacob Gotlieb, avocats et René Geoffrion, gérant de ventes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pouries objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités le commerce comme .manufacturiers et marchands de billots, bois de charpente, pulpe, bois de pulpe, papier et autres produits ou sous-produits du bois et de la pulpe, sous le nom de \"Best Lumber Co.\" Le capital de la compagnie est divisé en 250 actions sans valeur nominale ou au pair et en 500 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $15,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, suppléant, 29520 P.FRENETTE.Bordeleau Electrical Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze janvier 1951, constituant en corporation: Ariette Bordeleau, fille majeure, Moe Steinberg et Ben Steinberg, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer, faire le commerce et installer de la machinerie, des appareils, dispositifs ou accessoires électriques de toute nature quelconque, sous le nom de \"Bordeleau Electrical Supplies Ltd.\", avec un capital de $10,000 divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune et en 800 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Bourmont Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1951, constituant en corporation: Charles-Henri Bolduc, camionneur, Zenon Morin, commis, tous deux de Monet, et Joseph-Arthur Gagnon, vérificateur, de Val d'Or, tous du district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Faire et exercer le commerce d'entrepreneurs, constructeurs, sous toutes ses formes; exercer le commerce de transport général, sous le nom de \"Bourmont Transport Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of January, 1951, incorporating: Nathan Cotler, John Jacob Gotlieb, advocates, and René Geoffrion, sales manager, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of manufacturers of and dealers in logs, timber, pulp, pulpwood, paper and other products or by-products cf wood, and pulp, under the name of \"Best Lumber Co.\".The capital stock of the Company is divided into 250 shares having no nominal or par value, and into 500 preferred shares of $100.each, and the amount with which the company will commence its.operations will be $15,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this nineteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Bordeleau Electrical Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of January, 1951, incorporating: Ariette Bordeleau, spinster, Moe Steinberg and Ben Steinberg, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in and install electric machinery, apparatus, appliances or supplies of any nature whatsoever, under the name of \"Bordeleau Electrical Supplies Ltd.\", with a capital stock of $10,000 divided into 200 common shares of $10 each, and 800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Bourmont Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1951, incorporating: Charles Henri Bolduc, truckman, Zenon Morin, clerk, both of Monet, and Joseph Arthur Gagnon, auditor, of Val d'Or, all of the judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on and engage in the business of contractors, builders, under all the forms thereof ; to carry on the transportation business in general, under the name of \"Bourmont Transport Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL OAZETTE, Quebec, February SUh, 1961, Vol.83, No.8 693 Bridle & Saddle Hunt Club Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-six janvier, 1951, constituant en corporation: Paul Champagne, Marcel Bélanger, avocats, de la cité de Montréal, et Henri Masson-Loranger, avocat, Conseiller du Roi, de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Organiser et donner des cours d'équitation ou de conduite de chevaux en général; Faire le commerce en général des chevaux et des poneys et avoir et opérer des salles et chevaux de monte et reproduction, sous le nom de \"Bridle & Saddle Hunt Club Incorporated\", avec un capital de $10,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Canterbury Clothing Company Avis est done qu'enn vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit janvier 1951, constituant en corporation: Harry Blank, avocat, June Kirlin, Mavis Grant et Syjvia Rabinovitch, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le négoce ou le commerce de vêtements de toute sorte, sous le nom de \"Canterbury Clothing Company\", avec un capital de $10,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant.29520 P.FRENETTE, \" Champlain Sports Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt deux janvier 1951, constituant en corporation: Emmanuel Bilodeau, négociant, Dame Marie-Jeanne Gauthier Bilodeau, ménagère, épouse con-tractuellement séparée de biens dudit Emmanuel Bilodeau, tous deux de Beauport, Napoléon Fa-lardeau, négociant, et Dame Flore Ida Marois Falardeau, ménagère, épouse séparée de biens dudit Napoléon Falardeau, de la cité de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Fabriquer, manufacturer, vendre tout article de sport, équipements de chasse et de pêche commerciales ou sportives, sous le nom de \"Champlain Sports Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Bridle & Saddle Hunt Club Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-sixth day of January, 1951, incorporating: Paul Champagne, Marcel Bélanger, advocates, of the city of Montreal, and Henri Masson-Loranger, advocate, King's Counsel, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To organize and give courses in equitation or horsemanship in general; To deal generally in horses and ponies; to have and operate academics and keep riding horses and breeders, under the name of Briddle & Saddle Hunt Club Incorporated\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 sliares of $100 each.The head office of the company will be at Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Canterbury Clothing Company Notice is hereby given that under part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, incorporating: Harry Blank, advocate, June Kirlin, Mavis Grant and Sylvia Rabinoyich, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with clothing of every sort, under the name of \"Canterbury Clothing Company\", with a capital stock of $40,000.divided into 200 preferred shares having a par value of $100, each, and 200 common shares having a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Champlain Sports Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of January, 1951, incorporating: Emmanuel Bilodeau, merchant, Dame Marie Jeanne Gauthier Bilodeau, housewife, wife separate as to property by marriage contract of said Emmanuel Bilodeau, both of Beauport, Napoléon Falardeau, merchant, and Dame Flore Ida Marois Falardeau, housewife, wife separate as to property of said Napoléon Falardeau, of the city of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture, make and sell sporting goods of all kinds, hunting gear and fishing tackle both for commercial or pleasure purposes, under the name of \"Champlain Sports Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each. 694 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2k février 1951, Tome 83, N° 8 Le siège social de la compagnie sera à 8^, rue St-Joseph, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520-o L.DÉSILETS.Citadel Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi ties compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, tics lettres patentes en date du dix-huit janvier 1951, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, Clifford George Meck, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, teneurs de livres et Cecil Bruce Cook, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Sujet aux dispositions de la Loi des assurances de Québec, diriger et exercer le commerce comme courtiers et agents d'assurances en général et le négoce d'immeubles, sous le nom de \"Citadel Enterprises Inc.\" Le capital autorisé de la compagnie sera composé de $10,000 divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.The head office of the company will be at 8}^, Saint Joseph street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520 Deputy Attorney General.Citadel Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, incorporating: Ernest William Mockridgc, manager, Clifford George Meek, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, bookkeepers and Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Subject to the provisions of the Quebec Insurance Act, to conduct and carry on the business of insurance brokers and agents generally and of dealing in real estate, under the name of \"Citadel Enterprises Inc.\".The authorized capital stock of the company shall consist of $10,000 divided into 1,000 shares of the par value of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Confides Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept janvier 1951, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Wcstmount, Theodore H.Shapiro, avocat de ville Mont-Royal et Jean McFarlane, dactylographe, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements et d'immeubles, sous le nom de \"Confides Corporation\", avec un capital de $500,000 divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 4,750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520 P.FRENETTE.Confides Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1951, incorporating: Benjamin Robinson, advocate and King's Counsel, of the City of Wcstmount, Theodore H.Shapiro, advocate, of the Town of Mount Royal, and Jean McFarlanc, typist, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and real estate company, under the name of \"Confides Corporation\", with a capital stock of $500,000.divided into 250 common shares of $100.each, and 4750 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Di Pietro & Frères Inc.(Mount-Royal) Di Pietro & Frères Inc.(Mount-Royal) Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the sixteenth du seize janvier 1951, constituant en corporation: day of January, 1951, incorporating: John Di John Di Pietro, tailleur, Jeannette Gaudette, Pietro, tailor, Jeannette Gaudette, wife separated épouse séparée de biens de John Di Pietro et as to property of John Di Pietro,.and Albert Albert Di Pietro, tailleur, tous des cité et district Di Pietro, tailor, all of the City and Judicial judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: District of Montreal, for the following purposes: Entreprendre et exercer le commerce comme To engage in and carry on the business of tailleurs, confectionneurs, dessinateurs et faire tailors, outfitters, designers, and generally deal le commerce général de vêtements, sous le nom in clothing, under the name of \"Di Pietro & de \"Di Pietro & Frères Inc.(Mount-Royal), Frères Inc.(Mount-Royal)\", with a capital stock avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions of $40,000.divided into 4,000 shares of $10.de $10 chacune.each.\u2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 24tk, 1951, Vol.83, No.8 695 Le siège social de la compagnie sera à 1899 est, avenue Mont-Royal, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 195L L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520 P.FRENETTE.The head office of the Company will be at 1899 Mount-Royal Avenue East, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Di Pietro & Frères Inc.(Notre-Dame) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du seize janvier 1951, constituant en corporation: John Di Pietro.tailleur.Antonio Di Pietro, rentier, tous deux de la cité de Montréal, et Pascal Di Pietro, tailleur de Stc-Dorothce, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre et exercer le commerce comme tailleurs, manufacturiers, confectionneurs, dessinateurs et marchands de vêtements en général, sous le nom de \"Di Pietro & Frères Inc (Notre-Dame)\", avec un capital de $10,000 divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2617 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Di Pietro & Frères Inc.(Notre-Dame) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixteenth day of January, 1951, incorporating: John Di Pietro, tailor, Antonio Di Pietro, pensioner, both of the City of Montreal, and Pascal Di Pietro, tailor, of Ste Dorothée, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on the businesses of tailors, manufacturers, outfitters, designers and general dealers in clothing, under the name of \"Di Pietro & Frères Inc.(Notre-Dame)\", with a capital stock of $40,000.divided into 4,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the Company will be at 2617 Notre-Dame St.West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o .Deputy Attorney General.Eastman Copper Corporation Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit janvier 1951, constituant en corporation: Frank J.Dolan, comptable, George Arthur Ovenden, comptable.Lottie Pachal, dactylographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Eastman Copper Corporation Limited\" (Libre de» responsabilité personnelle), avec un capital de $40,000 divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagne sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Emira Ltd.Eastman Copper Corporation Limited (No Personal Liability) 0 Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, incorporating: Frank J.Dolan, accountant, George Arthur Ovendon, accountant, Lottie Pachal.typist, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals, whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable, by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Eastman Copper Corporation Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $40,000.divided into 40,000 shares of $1.each.The shareholders of the company shall incur no personal liability in excess of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares; The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Emira Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have 696 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, U février 1951, Tome 88, N° 8 été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du drx-sept janvier 1951, constituant en corporation: Marcel Lajeunesse, avocat, Alcide Grenon, comptable, Bella Bugeaud, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun de leurs spécialités et tous ou aucun des commerces comme marchands de quincaillerie, sous le nom de \"Emira Ltd.\", Le capital de la compagnie est divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520 P.FRENETTE.Forget et Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par lé Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt janvier 1951, constituant en corporation: Jérémie Forget, marchand, Charles Forget, agent, et Dame Thérèse Dion, épouse séparée de biens dudit Jérémie Forget, tous de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Faire le commerce et la vente d'huile, gazoline et succédanés; voitures automobiles et accessoires; l'installation et entretien des brûleurs à l'huile, poêles et fournaises à l'huile; entreprendre la construction de maisons, sous le nom de \"Forget et Fils Limitée\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE, been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1951, incorporating: Marcel Lajeunesse, advocate, Alcide Grenon, accountant, Bella Bugeaud, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on in all or any of their branches, all or any of the business of hardware merchants, under the name of \"Emira Ltd.\", The capital stock of the company is divided into 100 shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $500.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Forget et Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of January, 1951, incorporating: Jérémie Forget, merchant, Charles Forget, agent, and Dame Thérèse Dion, wife separate as to property of said Jérémie Forget, all of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To deal in and sell oil, gasoline and substitutes of same; motor vehicles and accessories; engage in the installation and servicing of oil-burners, oil stoves and furnaces; undertake the building of houses, under the name of \"Forget et Fils Limitée\", with a capital stock of $100,000 divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Frank Round & Son Ltd.\u2022 Frank Round & Son Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Provin-vince de Québec, représenté par M.Alfred Moris- ce of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.Q.1941, des lettres patentes en date du onze jan- 1941, bearing date the eleventh day of January, vier 1951, constituant en corporation: John Bum- 1951, incorporating: John Bumbray, King's bray, conseil en loi du Roi, Lowell Caverhill Car- Counsel, Lovel Caverhill Carroll, King's Counsel, roll, conseil en loi du Roi, tous deux de Mont- both of Mount-Royal, Jean-Paul Cardinal, Jehan Royal, Jean-Paul Cardinal, Jehan Perdriau, avo- Perdriau, advocates, and Françoise Caisse, secre-cats et Françoise Caisse, secrétaire, tous trois de 'tary, all three of Montreal, all in the judicial disMontréal, tous du district judiciaire de Montréal, trict of Montreal, for the following purposes: pour les objets suivants: Manufacturer, négocier et faire le commerce To manufacture and deal in and with floor de prélarts, carpettes, meubles, fournitures et ac- converings, carpets, house furniture, furnishings cessoires de maison, matières à nettoyage, pro- and supplies, cleaning material, textiles and any duits textiles et tous objets semblables et leurs similar objects and accessories and parts thereof; accessoires et pièces; et exercer le commerce géné-^ and carry on the business of general dyeing and ral de teinturerie et de nettoyage, sous le nom de cleaning, under the name of \"Frank Round & \"Frank Round & Son Ltd.\", avec un capital de Son Ltd.\", with a capital stock of $50,000 divided $50,000 divisé en 3,000 actions ordinaires d'une into 3,000 common shares of a par value of $10 valeur au pair de $10 chacune et en 400 actions each, and 400 preferred shares of a par value of privilégiées d'une valeur au nair de $50 chacune.$50 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont- district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le onze Dated at the office of the Attorney General, janvier 1951.this eleventh day of January, 1951.Iy'Assistant'procureur général, L.DÉSILETS, 29520 L.DÉSILETS.29520-o Deputy Attorney General, 1 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2#h, 1951, Vol.88, No.8 697 Garage de Fleurimont Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze janvier 1951, constituant en corporation: Julian Gaz-dik, gérant, Micaela Pap, ménagère, épouse séparée de biens de Julian Gazdik, et John Michael Schlesinger, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un garage, sous le nom de \"Garage De Fleurimont Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de,$100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.General Notions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix janvier 1951, constituant en corporation: John Randall Phillips, Albert Moyse et Alfred Elkin, tous marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, sauf Alfred Elkin, domicilié à Préfontaine, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce de textiles de toute nature et description, sous le nom de \"General Notions Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 190 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 ' L.DÉSILETS.General Signs Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du douze janvier 1951, constituant en corporation: Roy Fraser Elliott, avocat, Lillian Viola Armstrong, Amy Jean Fitsgerald et Margot Mary Quinn, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de panneaux-réclames de toute sorte, nature et description, sous le nom de \"General Signs Corpo-taion\", avec un capital de $4,000 divisé en 4,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8 ouest, rue Craig, Montréal, district judiciaire de Montréal.t , Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Garage de Fleurimont Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of January, 1951, incorporating: Julian Gazdik, manager, Micaela Pap, housewife, wife separate as to property of Julian Gazdik, and John Michael Schlesinger, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a garage, under the name of \"Garage De Fleurimont Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1951.L.DÉSILETS.29520-o Deputy Attorney General.General Notions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of January, 1951, incorporating: John Randall Phillips, Albert Moyse and Alfred Elkin, all merchants, of the City and Judicial District of Montreal, except Alfred Elkin, residing at Pre-fontaine, Judicial District of Terrebonne, for the following purposes : To carry on the business of manufacturing and dealing in textiles of every nature and description, under the name of \"General Notions Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 190 preferred shares having a par value of $100.each, and 1,000 common shares having a par value of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of January, 1951.L.DÊSDLETS, 29520-o Deputy Attorney General.General Signs Corporation - Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, bearing date the twelfth day of January, 1951, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, Lillian Viola Armstrong Amy Jean Fitzgerald and Margot Mary Quinn, stenographers, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in signs of every kind, nature and description, under the name of \"General Signs Corporation, with a capital stock of $4,000.divided into 4,000 shares of $1.each.The head office of the Company will be at 8 Craig Street West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1951.\u201e L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General. 698 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1951, Tome 83, N° 8 General Waste & Wares Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze janvier 1951, constituant en corporation: Ben Schecter, Moses Moscovitch, avocats et Margaret McMartin, commis, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objtes suivants: Exercer le commerce comme marchands, négociants et distributeurs de meubles, articles de maison, textiles, poches et sacs de toutes sortes, papier, cartons, boîtes, métaux et bouteilles, neufs ou usagés, sous le nom de \"General Waste & Wares Ltd.\", avec un capital de .540,000 divisé en 330 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.General Waste & Wares Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of January, 1951, incorporating: Ben Schecter, Moses Moscovitch, advocates, and Margaret McMartin, clerk, spinster, all .of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as merchants, dealers in and distributors of furniture, household articles, textiles, bags and sacks of all kinds, paper, cartons, boxes, metals and bottles, whether new or used, under the name of \"General Waste & Wares Ltd.\", with a capital of $40,000.divided into 380 preferred shares of the par value of $100.each*, and 200 common shares of the par value of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.G.L.Vise Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 1951, constituant en corporation: Gérard Lapointe, iindustriel, Dame Lauretta Marceau Lapointe, ménagère, épouse séparée de biens de Gérard Lapointe, et Joseph Marceau, commerçant, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Agir comme distributeurs de machines, outils et pièces de rechange qui y sont adaptables, s,ous le nom de \"G.L.Vise Limited\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec, Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.G.L.Vise Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January 1951, incorporating: Gérard Lapointe, industrialist* Dame Lauretta Marceau Lapointe, housewife, wife separate as to property of Gérard Lapointe, and Joseph Marceau, trader, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To act as distributors of machines, tools and spare parts adaptable to same, under the name of \"G.I.Vise Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.I Maine's Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit janvier 1951, constituant en corporation: Max Bernfeld, avocat et conseil en loi-du Roi, Milton Le win Klein, avocat et Arthur Daniel Ruby, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme marchands et négociants de vêtements de toute sorte et description, sous le nom de \"Helaine's Incorporated\", avec un capital de 810,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont-< real, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520 P.FRENETTE.Helaine's Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, incorporating: Max Bernfeld, advocate and King's Counsel, Milton Lewin Klein, advocate, and Arthur Daniel Ruby, chartered accountant, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of merchants and dealers in wearing apparel of every kind and description, under the name of \"Helaine's Incorporated\", with a capital stock of $10,000.divided into 100 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 24th, 1951, Vol.83, No.8 699 Jean Paul Fecteau ct Cie Inc.Jean Paul Fecteau and Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date, du dix-sept janvier 1951, constituant en corporation: Y von Jasmin, avocat, Lucienne Méri-neau et Rita Dufresne, secrétaire, filles ma-eures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer sous toutes ses formes, les commerces de* marchands de bois, manufacturiers de portes et châssis, quincailliers, spus le nom de \"Jean Paul Fecteau et Cie Inc.\"\u2014\"Jean Paul Fecteau and Co.Inc.\", avec un capital de §40,000 divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune, et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal-Sud, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Kra-Bcrn Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept janvier 1951, constituant en corporation: Jack Kraft, marchand, Mary Kraft, ménagère, épouse séparée de biens dudit -Jack Kraft, Edith Pomerantz, secrétaire, et David Litner, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général d'habillement, vêtements, fournitures et accessoires de toute description, sôus le nom de \"Kra-Bern Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520 P.FRENETTE.Lake Shore Homes Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize janvier 1951, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi du Roi, Jean McFarlane, dactylographe, fille majeure, tous de la cité de Montréal, Lucien Roux, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Westmount et Théodore H.Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Lake Shore Homes Ltd.\", avec un capital de $60,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Jean Paul Fecteau et Cie Inc.Jean Paul Fecteau and Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January 1951, incorporating: Yyon Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau and Rita Dufresne, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the folic wing purposes: To carry on, under all the forms thereof, the business of lumber merchants, manufacturers of doors, ans sashes, hardware dealers, under the name of \"Jean Paul Fecteau et Cie Inc.\"\u2014 \"Jean Paul Fecteau and Co.Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal-South, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Kra-Bern Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1951, incorporating: Jack Kraft, merchant, Mary Kraft, housewife, separate as to property of the said Jack Kraft, Edith Poine-rantz, secretary, and David Litner, advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal generally in clothing, wearing apparel, furnishings and accessories of every description, under the name of \"Kra-Bern Ltd.\", wiht a capital stock of $40,000.divided into 1,000 preferred shares of a par value of $10.each, and 3,000 common shares of a par value of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Lake Shore Homes Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of January, 1951, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Jean McFarlane, typist, spinster, both of the City of Montreal, Lucien Roux, advocate and King's Counsel, of the City of Westmount, and Theodore H.Shapiro, advocate, of the Town of Mount-Royal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under, the name of \"Lake Shore Homes Ltd.\", with a capital stock of $60,000.divided into 100 common shares of $100.each, and 500 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General. 700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1951, Tome 83, N° 8 La Plomberie Générale de Rimouski Inc.General Plumbery of Rimouski Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du dix-huit janvier 1951, constituant en corporation: Françoix-Xavier Desjardins, plombier, tous de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer le commerce de plomberie et ferblanterie et de systèmes de chauffage et accessoires, sous le nom de \"La Plomberie Général de Rimouski Inc.\"\u2014\"General Plumbery of Rimouski Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Lapointe & Bélanger Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 1951, constituant en corporation : Gérard Lapointe, machiniste, Dame Lauretta Marceau Lapointe, épouse contractuelle-ment séparée de biens de Gérard Lapointe, tous deux de la cité de Québec, et Gérard Bélanger, machiniste, d'Ancienne Lorette, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exploiter un ou des ateliers mécaniques; faire le commerce ou le négoce de véhicules-automobiles, sous le nom de \"Lapointe & Bélanger Ltée\", avec un capital de $10,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à l'Ancienne Lorette, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Lavage d'Eglise Campeau Church Cleaning Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.Alfred [orisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du neuf janvier 1951, constituant en corporation: Ben Bernstein, conseil en loi du Roi, Maurice J.Boxer, avocats et Dame Leah Levy, épouse séparée de biens de Louis lefcovitch, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à nettoyer, réparer, rénover, embellir et restorer des bâtisses, sous le nom de \"Lavage d'Église Campeau Church Cleaning Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.La Plomberie Générale de'Rimouski Inc.General Plumbery of Rimouski Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Compinies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth, day of January, 1951, incorporating: François-Xavier Desjardins, plumber, Edmond Desjardins, plumber, and Maurice Blanchette, master plumber, all of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on the plumbing trade and that .of tinsmith and to deal in heating systems and accessories, under the name of \"La Plomberie Général de Rimouski Inc.\"\u2014\"General Plumbery of Rimouski Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Lapointe & Bélanger Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1951, incorporating: Gérard Lapointe, machinist, Dame Lauretta Marceau Lapointe, wife separate as to property by marriage contract of Gérard Lapointe, both of the city of Quebec, and Gérard Bélangçr, machinist, of Ancienne Lorette, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate one or more machine shops; to trade and deal in and with motor vehicles, under the name of \"Lapointe & Bélanger Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Ancienne Lorette, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Lavage d'Eglise Campeau Church Cleaning Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of January, 1951, incorporating: Ben Bernstein, King's Counsel, Maurice J.Boxer, advocates, and Dame Leah Levy, wife separate as to property of Louis Lefcovitch, stenographer, all of of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of cleaning, repairing, renovating, embellishing, restoring buildings, under the name of \"Lavage d'Église Campeau Church Cleaning Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each, and 100 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 24th, 1951, Vol 83, No.8 701 Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Lavage de Vitres Campeau Window Cleaning Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix janvier 1951, constituant en corporation: Ben Bernstein, conseil en loi du Roi, Maurice J.Boxer, avocats, Dame Leah Levy, sténographe, épouse séparée de biens de Louis Lefco-vitch, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à nettoyer des fenêtres, sous le nom de \"Lavage de Vitres Campeau Window Cleaning Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Le Comité* du Troisième Centenaire du Cap de la Madeleine Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix huit janvier 1951, constituant en corporation sans capital actions: Raoul Rocheleau, secrétaire trésorier, Sylvio Hénaire, industriel, Jean Paul Massicotte, commerçant, Paul Dupuis, journaliste, Roger Lord, ingénieur civil, Paul Descoteaux ingénieur civil, Charles-Emile Montrain, hôtelier, Antonin Tou-pin, opérateur, Alphonse Denis, chef de gare, Henri Garneau, croque-mort, Lucien Bergeron, commis, Maurice Beaudet, gérant, François Beaumier, photographe, Laurent Langis, employé civique, et J.-Édouard Biron, comptable, tous du Cap de la Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: La constitution d'un organisme pour fins patriotiques, locales et régionales, ayant pour but principal l'organisation et la célébration des fêtes qui marqueront l'avènement du tricentenaire de la Cité du Cap-de-la-Madeleine, sous le nom de \"Le Comité du Troisième Centenaire du Cap de la Madeleine Inc.\" Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens, immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Cap de la Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Lined le Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Dated at the office of the Attorney General this ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Lavage de Vitres Campeau Window Cleaning i Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of January, 1951, incorporating: Ben Bernstein, King's Counsel, Maurice J.Boxer, advocates, Dame Leah Levy, stenographer, wife separate as to property of Louis Lefcovitch, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of cleaning windows, under the name of \"Lavage de Vitres Campeau Window Cleaning Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 100 common shares of the par value of $100.each, and 100 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the -Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Le Comité du Troisième Centenaire du Cap de la Madeleine Inc.Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Raoul Rocheleau, secretary-treasurer, Sylvio Hénaire, industrialist, Jean Paul Massicotte, merchant, Paul Dupuis* journalist, Roger Lord, civil engineer, Paul Descoteaux, civil engineer, Charles Emile Mongrain, hotel-keeper, Antonin Tou-pin, operator, Alphonse Denis, station master, Henri Garneau, funeial director, Lucien Bergeron, clerk, Maurice Beaudet, manager, François Beaumier, photographer, Laurent Langis, civic employee,.and J.Edouard Biron, accountant, all of Cap de la Madeleine, Judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: The constitution of an organization for patriotic purposes, both local and regional, having its main aim the organization and celebration of feasts marking the coming tercentenary of the City of Cap-de-la-Madeleine, under the name of \"Le Comité du Troisième Centenaire du Cap de la Madeleine Inc.\" The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000 The head office of the corporation will be at Cap de la Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Lincelle Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 702 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1951, Tome 83, N° 8 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix janvier 1951, constituant en corporation: Irwin A.Frankel, avocat, Louis M.Benjamin, avocat, et Sadie Gersovitz/ secrétaire, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce comme entrepreneurs et constructeurs en général, sous le nom de \"Lincelle Realties Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of January, 1951, incorporating: Irwin A.Frankel, advocate, Louis M.Benjamin, advocate, and Sadie Gersovitz, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of contractors and builders in general, under the name of \"Lincelle Realties Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 100 common shares of $100.each, and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General tlris tenth day of January 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Lino-Poseur, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du seize janvier 1951, constituant en corporation: John Richard Hyde, Roland-Gérard Le-françois, Jean-Jules Gadbois, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploirer un commerce de fournitures, garnitures et d'ameublement d'hôtel et de maison, et fournir les services s'y rapportant, sous le nom de \"Lino-Poseur, Ltée\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 action de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Mill-Knit Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze janvier 1951, constituant en corporation; Emmanuel Cooke, avocat, Lucy V.Clarke, secrétaire et Jack Miller, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce général de tous articles faits de laine, coton, soie et matières semblables, sous le nom de \"Mill-Knit Ltd.\", avec un capital de $49,900 divisé en 499 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1030 rue Smith, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Lino-Poseur, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixteenth day of January, 1951, incorporating: John Richard Hyde, Roland Gérard Lafrançois, Jean Jules Gadbois, all advocates of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in hotel and household furniture, furnishings and fittings, and to provide services connected therewith, under the name of \"Lino Poseur, Ltée\", with a capital stock of $30,000 divided into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal judicial district of Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Mill-Knit Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of January, 1951, incorporating; Emmanuel Cooke, advocate, Lucy V.Clarke, secretary, and Jack Miller, merchant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in generally all articles made out of wool, cotton, silk and similar materials, under the name of \"Mill-Knit Ltd.\", with a capital stock of $49,900.divided into 499 shares of $100 each.The head office of the Company will be at 1030 Smith Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 24th, 1951, Vol.83, No.8 703 Minerva Watch Company La Compagnie des Montres Minerva Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre janvier 1951, constituant en corporation: Monique Lacoursière, sténographe, Amédée Monet et Yavan Mercure, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer comme manufacturiers et marchands, le commerce de tout ce qui est généralement considéré comme relevant du commerce et de la manufacture dite de \"Bijouterie\", sous le nom de \"Minerva Watch Company\"\u2014\"La Compagnie des Montres Minerva\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 cha-cure.Le siège social de la compagnie est situé au numéro 5269, rue Gamier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Minolet Brands Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276 S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix janvier 1951, constituant en corporation: Moses Abraham Fels, Sol Sidney Fels, avocats et Audrey Sutherland, secrétaire, épouse séparée de biens de John M.-A.Sutherland, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles effets et marchandises qui peuvent être requis et utilisés par les boulangers et confiseurs en général, sous le nom de \"Minolet Brands Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4014 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Montreal Terrazo Tile & Marble Limited Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec des lettres patentes ,en date du dix-huit janvier 1951: constituant en corporation:Louis Gardonio: industriel, Catherine Tesolin .ménagère, épouse séparée de biens de Louis Gardonio et dûment autorisée par lui, et Joseph-Alphonse Thibault, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre et faire le commerce de briques de toute catégorie et description, tuile, terrazo, marbre; Exercer le commerce et l'industrie d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de Minerva Watch Company La Compagnie des Montres Minerva Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fourth day of January, 1951, incorporating: Monique Lacourcière, stenographer, Amédée Monet and Yvan Mercure, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and merchants, to deal in anything which is generally considered as being as connected with the jewellery, and the jewellery manufacturing business under the name of \"Minerva Watch Company\"\u2014\"La Compagnie des Montres Minerva\", with a capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at No.5269 Garnier Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Minolet Brands Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of January, 1951, incorporating: Moses Abraham Fels, Sol Sidney Fels, advocates, and Audrey Sutherland, secretary, wife separate as to property of John M.A.Sutherland, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise which may be required and used by bakers and confectioners generally, under the name of \"Minolet Brands Inc.\", with a capital stock of $50,000.divided into 100 common shares of a par value of $100.each, and 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at 4014 Notre Dame St.West, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of January 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Montreal Terrazo Tile & Marble Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, incorporating: Louis Gardonio, industrialist, Catherine Tessolin, housewife, wife separate as to property of Louis Gardonio and duly authorized by him, and Joseph Alphonse Thibault, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, purchase, sell and deal in bruck of every class and description, tiles, terrazo, marble; To carry on the business and industry of general contractors and builders under the name of 704 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1951, Terne 88, N° 8 \"Montreal Terrazo Tile & Marble Limited\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant.29520-Ô P.FRENETTE.Montreal Tile Terrazzo and Marble Employers' Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Quelle, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Reginald D.Tormey, Gérard Corbeil, avocats et Léo Davignon, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts et le bien-être général de ceux qui s'occupent de l'industrie du terrazzo, et de la tuile et du marbre, sous le nom de \"Montreal Tile Terrazzo and Marble Employers' Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège soeial de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Montreal Trust Company Avis est donné qu'en vertu de la deuxième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du 10 février 1951, subdivisant les actions du capital de \"Montreal Trust Company\", divisé originairement en 80,000 actions d'une valeur au pair de $25 chacune, ces actions étant maintenant subdivisées en 400,000 actions d'une valeur au pair de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 10 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.\"Montreal, Terrazo Tile and Marble Limited\", with a capital stock of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General,, this eighteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Montreal Tile Terrazzo and Marble Employers' Association Notice is hereby given that under the provisions of Part in of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1951, incorporating without share capital: Reginald 1).Tormey, Gérard Corbeil, advocates, and Leo Davignon, accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To foster the interest and the general welfare of those engaged in the terrazzo, tile and marble industry, under the name of \"Montreal Tile Terrazzo and Marble Employers'' Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $100,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520 o Deputy Attorney General.Montreal Trust Company Notice is hereby given that under Part II of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the 10th day of February, 1951, subdividing the shares of the stock of \"Montreal Trust Company\", originally divided into 80,000 shares of the par value of $25 each, such shares now being subdivided into 400,000 shares of the par value of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this 10th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Novelty Creations Ltd.Novelty Creations Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- Srovince de Québec, représenté par M.Alfred ince of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-[orisset, conformément à l'article 2, chapitre set, in conformity with section 2, chapter 276, 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of, du dix janvier 1951, constituant en corporation: January, 1951, incorporating: Morton M.Lewis Morton M.Lewis, manufacturier, Bernard Dia- manufacturer, Bernard Diamond, advocate, both mond, avocat, tous deux de la cité de Montréal, of the City of Montreal, Martin Hirsekorn, ma-Martin Hirsekorn, manufacturier, et Louis nufacturer, and Louis Orenstein, advocate, both Oreinstein, avocat, tous deux de la cité d'Outre- of the City of Outremont, all in the Judicial Dis-mont, tous du district judiciaire de Montréal, trict of Montreal, for the following purposes: pour les objets suivants: Manufacturer, acheter ou faire le négoce et le To manufacture, buy or deal in and with toys commerce de jouets, création de carnaval et carnival creations, novelties, under the name o, nouveautés, sous le nom de \"Novelty Creations \"Novelty Creations Ltd.\", with a capital stock Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 of $40,000.divided into 300 common shares of actions ordinaires de $100 chacune et en 100 $100.each and 100 preferred shares of $100 each, actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the Company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial Distriet of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2#ht 1951, Vol.83, No.8 705 Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Pantel Inc.Avis est- donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize janvier 1951, constituant en corporation: Hyman Pantel, Jack Pantel, Alex Pantel et Saul Pantel, tous manufacturiers, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce comme manufacturiers de vêtements, robes, vêtements de sport et habillement de toute sorte et description, sous le nom de \"Pantel Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant.29520 P.FRENETTE.Pointe-Claire Milk Bar Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit janvier 1951, constituant en corporation: William Legault, administrateur, Ga-brielle Legault, secrétaire comptable, épouse séparée de biens dudit William Legault, tous deux de Pointe-Claire, et Jean-Léon Cliarlebois, avocat, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: D'exercer le commerce de restaurant sous le nom de \"Pointe-Claire Milk Bar Limited\", avec un capital de $49,000 divisé en 490 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera situé sur la Montée St-Jean, à l'angle du Boulevard Métropolitain, dans la ville de Poiute-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Quebec Mineral Exploration & Mining Co.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq janvier 1951, constituant en corporation: Ricliard Chartier, prospecteur minier, William Chartier, bourgeois, et Edouard Cornelias, photographe, tous de Sainte-Marguerite du Lac Masson, ditrict de Terrebonne, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches ou découvrir des mines et minerais; Faire toutes opérations qui consistent à fouiller, miner, charrie»-, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou quelque autre manière que ce soit ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d'en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces mine- Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1951.L.DÉSDLETS, 29520-o Deputy Attorney General.Pantel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of January, 1951, incorporating: Hyman Pantel, Jack Pantel, Alex Pantel and Saul Pantel, all manufacturers, of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of manufacturers in garments, dresses, sportswear and clothing of every kind and description, under the name of \"Pantel Inc.\", with a capital stock of $50,000.divided into 300 common shares of a par value of $100.each, and 200 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Pointe-Claire Milk Bar Limited Notice is hereby given tliat under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1951, incorporating: William Legault, executive, Gabrielle Legault, secretary, accountant, wife separate as~to property of said William Legault, both of Pointe-Claire, and Jean Léon Cliarlebois, advocate, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal for the following purposes: To carry on the restaurant business, under the name of \"Pointe-Claire Milk Bar Limited\", with a capital stock of $49,000, divided into 490 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montée St-Jean, at the corner of Metropolitan Boulevard, in the town of Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General.Quebec Mineral Exploration & Mining Co.(No Personal^ Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January, 1951, incorporating: Richard Chartier, mining prospector, William Chartier, retired, and Edouard Cornelias, photographer, all of Sainte-Marguerite du Lac Masson, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals; To carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may for the purpose of extracting any minerals wliatsoever, be mined dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise, dispose thereof, under the 706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1951, Tome 83, N° 8 rais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de 'Quebec Mineral Exploration & Mining Co.\" (No Personal Liability), avec un capital de $1,000,000 divisé en 1,000,000 d'actions de $1.chacune.Les actionnaires n'encourreront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions; Le siège social de la compagnie sera à Ste-Marguerite du Lac Masson, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.Roberto's Restaurant, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du treize janvier 1951, constituant en corporation: Edmée Fortin, sténographe, Lionel Lefèvre, comptable, tous deux de la cité de Montréal et Rodolphe Paré, procureur, de Lachine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme propriétaires d'hôtel, auberge, restaurant, café et maison de pension, sous le nom de \"Roberto's Restaurant\" Inc.avec un capital de $15,000 divisé en 150 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.name of \"Quebec Mineral Exploration & Mining Co.\" (No personal Liability), with a capital stock of $1,000,000 divided into 1;000,000 slia-rcs of $1 each.The shareholders shall incur no liability in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Ste-Marguerite du Lac Masson, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth day of January, 1951.P.FRENE1TE, .29520 Assistant Deputy Attorney General.Roberto's Restaurant, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of January, 1951, incorporating: Edmée Fortin, stenographer, Lionel Lefèvre, accountant, both of the city of Montreal, and Rodolphe Paré, barrister, of La-chine, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel, inn, restaurant, café and lodging house keepers, under the name of \"Roberto's Restaurant, Inc.\", with a capital stock of $15,000 divided into 150 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Rolaine Furs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix janvier 1951, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal et Cyrill E.Schwis-berg, avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour l'es objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de toutes sortes de fourrures et vêtements et accessoires en fourrures, sous le nom de \"Rolaine Furs Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 445 rue St-Pierre, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.Rolaine Furs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of January, 1951, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, secretary, both of the city of Montreal, and Cyril E.Schwisberg, advocate, of the city of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers of, and dealers in all kinds of furs and fur garments and accessories, under the name of \"Rolaine Furs .Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 445 St.Peter St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.Samuel Gibson Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date Samuel Gibson Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Wh, 1951, Vol.88, No.8 707 du douze Janvier 1951, constituant en corporation: David Lack, avocat, Pearl Auerbach, secrétaire, et Philip Gibson, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce qui consiste, à manufacturer et faire le commerce de boutons, garnitures, ornements, bijouterie et montres et autres articles et marchandises de même nature, sous le nom de \"Samuel Gibson Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.January, 1951, incorporating: David Lack, advocate, Pearl Auerbech, secretary, and Philip Gibson, merchant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in buttons, trimmings, ornaments, jewellery and watches, and other goods and merchandise of a similar nature, under the name of \"Samuel Gibson Inc.\", with a capital stock of $50,000.divided into 250 common shares at a par value of $100.each, and 250 preferred shares having a par value of $100.each.The head office of the company will be at Montreal Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.St.Hubert Furniture & Stove Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Governeur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix janvier 1941, constituant en corporation: Harolîl S.Freeman, B.Benno Cohen, avocats et Hyman Freeman, vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général comme manufacturiers et marchands de toutes sortes de meubles, appliques et dispositifs, nattes, tapis, carpettes et machinerie, sous le nom de \"St.Hubert Furniture & Stove Co.\", avec un capital de $65,000 divisé en 350 actions ordinaires de.$100 chacune et en 300 acions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29520 L.DÉSILETS.St.Hyacinthe Industries Ltd.Les Industries Si-Hyacinthe Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 1951, constituant en corporation: Juliette Trempe, secrétaire, André Charron, avocat, tous deux de la cité de Montréal, et Léona Girard, secrétaire, de la cité de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et faire le commerce du bois sous toutes ses espèces et dans tous ses usage en produits et sous-produits, sous le nom de \"St.Hyacinthe Industries Ltd.\"\u2014\"Les Industries St-Hyacinthe Ltée\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 500 actions sans valeur au pair ou nominale et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $2,500.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520-o P.FRENETTE.St.Hubert Furniture & Stove Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1951, incorporating: Harold S.Freeman, B.Benno Cohen, advocates, and Hyman Freeman, salesman, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers generally in all kinds of furniture, fixtures and appliances, mats, rugs, carpetsand macliinery, under the name of \"St.Hubert Furniture & Stove Co.\", with a capital stock of $65,000.divided into 350 common shares of $100.each and 300 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will- be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29520-o Deputy Attorney General.St.Hyacinthe Industries Ltd.Les Industries St-Hyacinthe Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1951, incorporating: Juliette Trempe, secretary, André Charron, advocate, both of the city of Montreal, and Léona Girard, secretary, of the city of West-mount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on business as lumber merchants under all the forms thereof, and for all its uses, products and by-products, under the name of \"St-Hyacinthe Industries Ltd.\"\u2014 \"Les Industries St-Hyacinthe Ltée\".The capital stock of the company will be divided into 500 shares without par or nominal value, and the amount with which the company will begin its operations is $2,500.The head office of the company will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520 Assistant Deputy Attorney General. 708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2k février 1951, Tome 83, N° 8 Sun Kun Wo Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze janvier 1951, constituant en corporation: Cham Tom, Chin Jung Wah et Henry G.Chan, tous restaurateurs des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme restaurateurs et manufacturer et faire le commerce général de bonbons, confiserie, pâtisserie, tartes et friandises, sous le nom de \"Sun Kun Wo Inc.\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1951.L'Assistant-proeureur général suppléant, 29520 P.FRENETTE.Sun Kun Wo Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January, 1951, incorporating: Cham Tom, Chin Jung Wah and Henry G.Chan, all restaurant-keepers, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurant-keepers and to manufacture and deal generally in sweets, confectionery-pastry, pies and delicacies, under the name of \"Sun Kun Wo Inc.\", with a capital stock of $30,000, divided into 300 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of January, 1951.P.FRENETTE, 29520-o Assistant Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Ant.Dernier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi ,S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 29 janvier 1951, à la compagnie \"Ant.Bernier Inc.'.', ratifiant son règlement numéro 9 augmentant son capital-actions de $150,000 à $3000,000, par la création de 1,500 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 29 janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521-0 L.DÉSILETS.Supplementary Letters Patent Ant.Bernier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the twenty-ninth day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Ant.Bernier Inc.\", ratifying its By-law number 9, increasing its capital stock from $150,000 to $300,000 ,by the creation of 1,500 preferred shares of $100 each subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of Januarv, 1951.L.DÉSILETS, 29521 Deputy Attorney General.Champlain Metal Industries, Inc.Champlain Metal Industries, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la premièie Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, supplementary let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent bearing date the twelfth day of province de Québec des lettres patentes supplé- February, 1951, were issued by the Lieutenant-mentaires, en date du 12 février 1951, à la com- Governor of the Province of Quebec, to the compagnie \"Champlain Metal Industries, Inc.\", rati- pany \"Chamnlain Metal Industries, Inc.\" ratifiant son règlement numéro 5: a) subdivisant fying its By-law number 5,: a) subdividing the les 200 actions communes de $100 chacune du 200 common shares of $100 each, of the authorized capital-actions autorisé de ladite compagnie en capital stock of the said company into 2,000 2,000 actions communes de $10 chacune; b) common shares of $10 each; b) increasing said augmentant tel capital-actions autorisé deN authorized capital stock from $20,000 to $70,000, $20,000 à $70,000, par la création de 500 actions by the creation of 500 preferred shares of $100 privilégiées de $100 chacune, comportant les each, carrying the rights, restrictions and privi-droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit leges enumerated in the said By-law.règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 12 Dated at the office of the Attorney General, février 1951.this twelfth day of February, 1951.L'Assistant-proeureur général, L.DÉSILETS, 29521-0 L.DÉSILETS.29521 Deputy Attorney General.Chas.Cusson Limitée Chas.Cusson Limitée Chas.Cusson Limited Chas.Cusson Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 12 février 1951, à la com- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twelfth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the com- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2#k, 1961, Vol.83, No.8 709 Eagnie \"Chas.Cusson Limitée\" \u2014 \"Chas.Cusson imited\", ratifiant son règlement spécial \"A\" portant son capital-actions de $49,000 à $1,049,-000 par la création de 100,000 actions privilégiées nouvelles de $10 chcaune sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 12 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29539-o .L.DÉSILETS.Clix Fastener Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 8 février 1951, à la compagnie \"Clix Fastener Corporation\", ratifiant son règlement N° 25, augmentant son capital autorisé de $50,000 à $100,000 par la création de 5,000 actions privilégiées catégorie A de $10 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 8 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.Corriveau et Frères Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 9 février 1951, à la compagnie \"La Cie de Meubles\u2014Corriveau\u2014 Furniture Co.\", constituée en corporation par lettres patentes du 20 juillet 1932, ratifiant: a) son règlement N° 17 changeant son nom en celui de \"Corriveau et Frères Limitée\"; b) son règlement N° 18 augmentant de $20,000 $100,-000 le capital-actions .autorisé, par la création de 800 actions communes additionnelles de $100 chacune; c) son règlement N° 19 changeant l'adresse du bureau principal de la compagnie de 72, rue Hériot, Drummondville, au numéro civique 104 de la rue Marchand, à Drummond-ville, P.Q.Daté du bureau du Procureur général, le 9 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521-0 L.DÉSILETS.Délorimier, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la prov-vince de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 11 janvier 1951, à la compagnie \"Délorimier, Limitée\", ratifiant son règlement \"C\" portant son capital-actions de $98,000 à $150,000 par la création de 520 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 11 janvier 195L L'Assistant-proeureur général, 29539-o \u2022 L.DÉSILETS.Dominion Manufacturing (Sportswear) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a pany \"Chas.Cusson Limitée\" \u2014 \"Chas.Cusson Limited\", ratifying its special By-law\"A\", increasing its capital stock from $49,000 to $1,049,000, by the creation of 100,000 new preferred shares of $10 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29539 Deputy Attorney General.Clix Fastener Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Clix Fastener Corporation\", ratifying its By-law No.25 increasing its authorized capital stock from $50,000 to $100,000 by the creation of 5,000 Class A preferred shares of $10 each carrying the rights, restrictions and privileges enumerated in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this 8th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521-o Deputy Attorney General.Corriveau et Frères Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the ninth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"La Cie de Meubles\u2014Corriveau\u2014 Furniture Co.\" incorporated by letters patent on July 20, 1932, ratifying: a) its By-law No.17 changing its name to that of \"Corriveau et Frères Limitée\"; b) its By-law No.18, increasing its authorized capital stock from $20,000 to $100,000 by the creation of 800 additional common shares of $100 each: c) its By-law No.19 changing the address of the company's head office, from 72 Hcriot Street, Drummondville, to civic number 104 Marchand Street, Drummondville, P.Q.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521 Deputy Attorney General.Délorimier, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters ^patent, bearing date the eleventh day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Délorimier, Limitée\", ratifying its By-law \"C\", increasing its capital stock from $98,000 to $150,000 by the creation of 520 additional common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29539 Deputy Attorney General.Dominion Manufacturing (Sportswear) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary i 710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2k février 1951, Tome 83, N° 8 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 31 janviers 1951, à la compagnie \"Dominion Manufacturing (Sportswear) Ltd.\", ratifiant son règlement \"A\" a) convertissant 584 actions de $100 chacune en 584 actions catégorie \"A\" de $100 chacune; b) subdivisant et convertissant 45 actions de $100 chacune en 4,500 actions catégorie \"B\" de $1 chacune; c) convertissant 371 actions de $100 chacune en 371 actions catégorie \"C\" de $100 chacune; d) augmentant le capital autorisé de la compagnie de $100,000 à $200,000, par la création de 1,000 actions a catégorie \"C\" additionnelles de $100 chacune; e) énumérant les droits, restrictions et privilèges attachés aux-dites actions catégorie \"A\", catégorie \"B\" et catégorie \"C\".Daté du bureau du Procureur général, le 31 janvier 1951.L'Assistant-proeureur général,** 29521 L.DÉSILETS.Duroform Shoulder Pad Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 6 février 1951, à la compagnie \"Duroform Shoulder Pari Corporation\", ratifiant son règlement N° 23, augmentant son capital de $20,000 à $95,000 par la création de 750 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 6 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.Grenon Construction Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 février 1951, à la compagnie \"Grenon Construction Company Limited\", ratifiant son règlement numéro 4 portant son capital-actions de $49,900 à $75,900, par la création de 260 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, sujettes aux mêmes privilèges et restrictions que ceux attachés aux actions privilégiées créées par les lettres patentes originaires du 17 juin 1947.Daté du bureau du Procureur général, le 6 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521-0 L.DÉSILETS.letters patent, bearing date the 31st day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Dominion Manufacturing (Sportswear) Ltd.\" ratifying its Special By-law \"A\": a) converting 584 shares of $100 each into 584 Class \"A\" shares of $100 each; b) subdividing and converting 45 sliares of $100 each into 4,500 Class \"B\" shares of $1 each; c) converting 371 shares of $100 each into 371 Class \"C\" shares of $100 each; d) increasing the company's authorized capital from $100,000 to $200,000, by the creation of 1,000 additional Class \"C\" shares of $100 each; e) enumerating the rights, restrictions and privileges of $100 each; e) enumerating the rights, restrictions and privileges attaching to the said Class \"A\", Class \"B\" and Class \"C\", shares.Dated at the office of the Attorney General, the 31st day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29521-0 Deputy Attorney General.Duroform Shoulder Pad Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Duroform Shoulder Pad Corporation\", ratifying its By-Law No.23 increasing its capital stock from $20,000 to $95,000 by the creation of 750 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 6th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 2952l-o Deputy Attorney General.Grenon Construction Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the sixth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, of the said Act, R.S.Q., 1941, to the company \"Grenon Construction Company Limited\", ratifying its By-law No.4 increasing its capital stock from $49,900 to $75,900, by the creation of 260 additional preferred shares of $100 each, subject to the same privileges and restrictions as those attaching to the preferred shares created by the original letters patent of the 17th of June, 1947.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521 Deputy Attorney General.% H.B.BigneU & Son, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 8 février 1951, à la compagnie \"H.B.Bignell & Son, Limited\", ratifiant son règlement spécial N° 1, augmentant son capital autorisé de $20,000 à $70,000 par la création H.B.Bignell & Son, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"H.B.Bignell & Son, Limited\", rati-fiying its Special By-Law No.1 increasing the authorized capital stock thereof from $20,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 24th, 1961, Vol.88, No.8 711 de 500 actions privilégiées de $100 chacune, coin-portant les droits, restrictions et privilèges mentionnés au sus;lit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 8 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.I.Iseman Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province cie Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 8 février 1951, à la compagnie \"I.Iseman Limited\", ratifiant son règlement No 21, augmentant son capital autorisé de $20,000 à $170,000 par la création de 15,000 actions privilégiées de $10 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 8 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.J.L.Welch Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 12 février 1951, à la compagnie \"J.L.Welch and Co., Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 février 1949, changeant son nom en celui de \"J.L.Welch Co.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 12 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29539 L.DÉSILETS.Land & Construction Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 8 février 1951, à la compagnie \"Land & Construction Company\", ratifiant son règlement spécial \"B\", augmentant son capital de $25,000 à $65,000 par la création de 400 nouvelles actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 8 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSIXETS.Les Produits Can-Mar Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 8 février 1951, changeant le nom de la compagnie \"Canac Marquis Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes du 20 juin 1950, en celui de \"Les Produits Can-Mar Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le 8 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521-0 L.DÉSILETS.to $70,030 by the creation of 500 preferred shares of $100 each, carrying the rights, restrictions and privileges mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 8th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521-0 Deputy Attorney General.I.Iseman Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"I.Iseman Limited\", ratifying its By-law No.21 increasing its authorized capital stock from $20,000 to $170,000, by the creation of 15,000 preferred shares of $10 each, carrying the rights, restrictions and privileges mentioned in the said By-law.** Dated at the office of the Attorney General, this 8th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 2952 l-o Deputy Attorney General.J.L.Welch Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"J.L.Welch and Co., Ltd.\" incorporated by letters patent dated the 10th of February, 1949, changing its name to that of \"J.L.Welch Co.Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this 12th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29539-0 Deputy Attorney General.Land & Construction Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Land & Construction Company\", ratifying Special By-law \"B\" thereof increasing its captai stock from $25,000 to $65,000 by the creation of 400 new preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the aforesaid By-law.Dated at the office of the Attorney General, the 8th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521-0 Deputy Attorney General.Les Produits Can-Mar Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the eighth day of February 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Canac Marquis Limitée\", incorporated by letters patent on June 20, 1950, to that of \"Les Produits Can-Mar Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521 Deputy Attorney General. 712 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1951, Tome 83, N° 8 Louis Donolo Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 6 février 1951, à la compagnie \"Louis Donolo Inc.\", ratifiant son règlement 25, augmentant son capital de $48,000 à $348,000 par la création de 3,000 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 6 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.Moreau's Barber School Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 9 février 1951, changeant le nom de la compagnie \"Vaughn's Barber School Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes du 18 septembre 1935, en celui de \"Moreau's Barber School Incorporated\".Daté du bureau du Procureur général, le 9 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521-0 L.DÉSILETS.P.E.Bcllerose & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 8 février 1951, à la compagnie \"P.E.Bellerose & Fils Inc.\", ratifiant son règlement spécial \"A\" augmentant de $149,-000 à $249,000 son capital-actions autorisé, par la création de 10,000 actions privilégiées de $10 chacune, comportant les droits, privilèges et restrictions énumérés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 8 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521-o L.DÉSILETS.Ritz Lace & Embroidery Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi (R.S.Q.1941, chapitre 276), des lettres patentes supplémentaires en date du 25 janvier 1951, à la compagnie \"Ritz Lace & Embroidery Limited\", ratifiant son règlement N° 3, augmentant son capital de $20,000 à $110,000 par la création de 90,000 actions privilégiées de $1 chacune et comportant les privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 25 janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.Southern Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 6 février 1951, à la compagnie \"Southern Sportswear Inc.\", rati- Louis Donolo Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Louis Donolo Inc.\", ratifying its By-Law 25 increasing its capital stock from $48,000 to $348,000 by the creation of 3,000 preferred shares of $100 each subject to the privileges and restrictions mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 6th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 2952l-o Deputy Attorney General.Moreau's Barber School Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the ninth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Vaughn's Barber School Incorporated\", incorporated by letters patent dated September 18, 1935, to that of \"Moreau's Barber School Incorporated\".Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29521 Deputy Attorney General.P.E.Bellerose & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the eighth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"P.E.Bellerose & Fils Inc.\", ratifying its special By-Law \"A\", increasing its authorized capital stock from $149,000 to $249,000, by the creation of 10,000 preferred shares of $10 each, carrying the rights, privileges and restrictions enumerated in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dayof February, 1951.L.DÉSILET, 29521 Deputy Attorney General.Ritz Lace & Embroidery Limited Notice is hereby given tliat under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, inconformity with section 2 of the said Act (R.S.Q.1941, chapter 276), to the company \"Ritz Lace & Embroidery Limited\", ratifying its By-law No.3 increasing its capital stock from $20,000 to $110,000, by the creation of 90,000 preferred shares of $1 each and carrying the privileges and restrictions mentioned in such By-law.Dated at the office of the Attorney General, the 25th day of January, 1951.L.DÉSIXETS, 29521-o Deputy Attorney General.Southern Sportswear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant* Governor of the Province ol Quebec, to \"the company \"Southern Sportswear Inc.\", ratify- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 24th, 1961, Voh 88, No.8 713 fiant son règlement N° 24, augmentant son capital de $10,000 à $100,000 par la création de 900 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 6 février 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 .L.DÉSILETS.Vogue Bags Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 31 janvier 1951, à la compagnie \"Vogue Bags Ltd.\", ratifiant son règlement No 20, augmentant son capital de $20,000 à $170,000 par la création de 15,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux privdèges et restrictions mentionnés au-susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 31 janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.W.C.MacDonald Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 31 janvier 1951, à la compagnie \"W.C.Macdonald Incorporated\", ratifiant son règlement N° 47, augmentant son capital de $20,000 à $674,700 par la création de 6,547 actions privilégiées de $100 chacune comportant les droits, restrictions et privilèges énu-mérés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 31 janvier 1951.L'Assistant-proeureur général, 29521 L.DÉSILETS.Zinc Oxide Company of Canada Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 13 février 1951, à la compagnie \"Zinc Oxide Company of Canada Limited\", ratifiant son règlement N° 36 portant son capital-actions de $120,000 à $1,120,000, par la création de 100,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau dn Procureur général, le 13 février 1961.L'Assistant-proeureur général, 29521-0 L.DÉSILETS.Ventes pour taxes ing its By-law No.24 increasing its capital stock from $10,000 to $100,000 by the creation of 900 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in such By-law.Dated at the office of the Attorney General, this 6th day of February, 1951.L.DÉSILETS, 2952l-o Deputy Attorney General.Vogue Bags Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of January, 1951, were \"issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Vogue Bags Ltd.\", ratifying its By-law No.20, increasing its capital stock from $20,000 to $170,000 by the creation of 15,000 preferred shares of $10 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the aforesaid By-law.Dated at the office of the Attorney General, this 31st day of January, 1951.L.DÉSILETS, 2952l-o Deputy Attorney General.W.C.MacDonald Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of January, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"W.C.Macdonald Incorporated\", ratifying its By-Law No.47 increasing its capital stock from $20,000 to $647,700 by the creation of 6,547 preferred shares of $100 each carrying the rights, restrictions and privileges enumerated in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 31st day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29521-0 Deputy Attorney General.Zinc Oxide Company of Canada Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the thirteenth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Zinc Oxide Company of Canada Limited\" ratifying its By-law No.36 increasing its capital stock from $120,000, to $1,120,000, by the creation of 100,000 preferred shares of $10 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of February, 1951.L.DÉSDLETS, 29521 Deputy Attorney General.Sales for Taxes Municipalité du comté de têmibcamingue Dans l'avis de vente pour taxes de cette municipalité publié dans la Gazette officielle de Québec, des 20 et 27 janvier 1951, aux pages 242 et «370, au nom de Pépin et DeCogter, de la corpo- municipality of the county of témiscamingue In the notice of Sale for Taxes of this municipality, published in the Quebec Official Gazette of January 20th and 27th, 1951, on pages 242 and 370, in the name of \"Pépin and DeCoster,\" of 714 GAZETTE OFF ICI ALLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1951, Tome 83, N° 8 ration municipale d'Evain.veuillez lire lot 49 subdivisions 26 à 29 et 36 à 41 au lieu de 26 à 41.Ville-Marie, le 8 février 1951.Le Secrétaire-trésorier du conseil de comté de Témiscamingue, 29535-0 JULES GRENIER.the municipal corporation of Evain, please read lot 49 subdivisions 26 to 29 and 36 to 41, instead of 26 to 41.Ville-Marie, February 8, 1951.JULES GRENIER.Secretary Treasurer of the County Council 29535 of Témiscaninguc.Province de Québec La Corporation municipale de comté du Lac-Saint-Jean-Est Avis public est donné par le soussigné E.-O.Hudon, secrétaire-trésorier de la corporation municipale de comté du Lac-Saint-Jean-Est, que conformément aux dispositions du code municipal et au règlenîent N° 60 du dit conseil de comté adopté le 10 septembre 1947 et approuvé par l'honorable Ministre des Affaires Municipale, les propriétés ci-après décrites seront vendues pour taxes, en l'hôtel-de-ville de Saint-Joseph-d'Alma, MERCREDI le VINGT-CINQUIÈME jour d'AVRIL, mil neur cent cinquante et un à DIX heures de l'avant-midi.Cette vente comprendra les bâtisses érigées sur les terrains mis en vente à moins de spécification contraire.Gaspard Turcotte, Saint-Gédéon : 1) Un emplacement situé dans la paroisse de Saint-Gédéon mesurant à l'ouest cinquante-deux pieds de front à l'est quarante-quatre oieds sur un cent cinquante-deux pieds de profondeur, borné en front à l'Ouest au chemin public, en arrière, vers l'est, au terrain de Didyme Tremblay, au Sud au terrain ci-après décrit, et au nord au terrain de Napoléon Therrien ou représentants; lequel terrain fait partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro Trois-B (ptie 3-b) du dixième rang du cadastre du canton SignaT, circonstances et dépendances.2) Un autre terrain contigu à celui ci-dessus décrit, mesurant -soixante-quinze pieds de largeur sur environ deux cent cinquante pieds de longueur, faisant également partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro trois-B (ptie 3-b).du dixième rang, du cadastre du canton SignaT, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances borné comme suit: en front vers l'ouest au chemin public, vers l'est au terrain de Basile Barrette, au vieux fossé qui s'y trouve, joignant au nord partie au terrain ci-dessus décrit et partie au terrain de Didyme Tremblay, et au sud au terrain de Basile Barrette.Taxes municipales: $1.77; taxes scolaires: $8.17; taxes d'aqueduc : 823.50.Total : $33.44.( Auguste Gagné et Lucien Gagné, Hébeitville-station: Un terrain et emplacement sis et situé en le village de Hébertville-station, dans le comté du Lac-Saint-Jean, mesurant cinquante-deux pieds de largeur sur un cent pieds de profondeur, faisant partie du lot numéro six-A-un (ptie 6-a-l) du cadastre officiel pour le deuxième rang Ouest du canton Labarrei avec bAtisses et dépendances, borné en front vers l'Ouest, au chemin Aima, en arrière à la profondeur vers l'est, au terrain de Henri Gervais ou représentants, joingnant au nord le terrain de Isaïe Lajoie ou représentants et au sud celui de Auguste Coulombe ou représentants sujet au chemin mitoyen situé entre la propriété de Rodolphe Maltais et Auguste Gagné.Taxes municipales: $16.76; taxes scolaires $113.80; taxes d'Église : $249.26.Total : $379.-82.Donné à Hébertville, le 13 janvier 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29414-6-2-o E.-O.HUDON.Province of Quebec Municipal Corpotation of the County of Lake Saint John-East Public notice is hereby given by the undersigned E.O.Hudon, secretary-treasurer of the Municipal Corporation of the County of Lake Saint-John-East, that pursuant to the provisions of the Municipal Code and of By-law No.60 of the said County Council ,adopted on the 10th of September, 1947, and approved by the Honourable the Minister of Municipal Affairs, the properties hereinbelow described will be sold for taxes in the Town Hall of Saint-Joseph D'Alma, on WEDNESDAY, the TWENTY-FIFTH day of APRIL, one thousand nine hundred and fifty-one at TEN o'clock in the forenoon.The said sale to include the buildings erected on the lots of land sold unless specified to the contrary.Gaspard Turcotte, Saint-Gédéon : 1.An emplacement situate in the parish of Saint-Gédéon, measuring on the west fifty-two feet in front, on the east forty-four feet by one hundred and fifty-two feet in depth, bounded in front to the west by the public road, in rear, to the east, by the land of Didyme Trembly, on the south by the land hereinafter described, and on the north by the land of Napoléon Therrien or representatives; the said lot of land forms part of the lot of land known and disignated as number three-B (Pt.3-b) of the tenth range on the cadastre for the township SignaT, circumstances and dependencies.2.Another lot of land continuous to the one above described, measuring seventy-five feet in width by about two hundred and fifty feet in length, also forming part of the lot of land known and described as number three-B (Pt.3-b) of the tenth range, of the casdastre for the township of SignaT \u2014 with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, bounded as follows : In front, towards the west, by the public road, towards the east by the land of Basile Barrette, at the old ditch found there, adjoining on the north partly the land hereinabove described and partly the land of Didyme Tremblay, and on the south by the land of Basile Barrette.Municipal taxes $1.77; School taxes: $8.17; Water tax: $23.50.Total: $33.44.Auguste Gagné and Lucien Gagné, Hébertville Station: A lot of land or emplacement lying and situate in the village of Hébertville-station, in the county of Lake Saint John, measuring fifty-two feet in width by one hundred feet in depth, forming part of lot six-a-one (Pt.6-a-l) on the official cadastre for the second west range of the township Labarre \u2014 with buildings and dependencies, bounded in front on the west by the Alma road, in rear at the depth towards the east, by the land of Henri Gervais or representatives, adjoining on the north the land of Isale Lajoie or representatives, subject to a \"mitoyen\" road situate between the property of Rodolphe Maltais and Auguste Gagné.Municipal taxes: $16.76; School taxes: $113.80; Church taxes $249.26.Total: $379.82.Given at Hébertville, January 31, 1951.E.O.HUDON, 29414-6-2 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Stfh, 1951, Vol 88, No.8 715 Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Municipalité du comté d'Abitibi Avis public vous est par les présentes donné par le soussigné, Laval Goulet, secrétaire-trésorier de la Corporation Municipale du comté d'Abitibi, que les immeubles avec bâtisses, circonstances et dépendances, ci-après mentionnées seront ven-f dues à l'enchère publique au Palais de Justice t à Amos, au lieu ordinaire des sessions de ce conseil le second jeudi du mois d'avril 1951, soit le DOUZE AVRIL, 1951, à DIX heures de l'avant-midi, pour non-paiement des taxes municipales, scolaires et repartition d'Église, frais et charge dues sur chacun de ces immeubles à moins que ces taxes, frais et charges ne soient plus tôt payés et acquittés avec les frais encourus avant la vente, savoir: Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Municipality of the County of Abitibi Public notice is hereby given by the undersigned, Laval Goulet, secretary-treasurer of the Municipal Corporation of the county of Abitibi that the immovables, with buildings, circumstance and dependencies, liereinafter mentioned, will be sold by public auction in the Court House at Amos, the usual meeting place of the said Council, on the second Thursday of the month of April, 1951, namely the TWELFTH day of APRIL, 1951, at TEN o'clock in the forenoon, for the non-payment of municipal and school taxes and church apportionments, costs and charges due on each of the said immovables, unless the said taxes, costs and charges be paid and acquitted, with costs incurred, before the sale, to wit: Corporation de Carpontier & Courville \u2014 Corporation of Carpentier & Courville Commission scolaire do Belcourt \u2014 School Commission of Belcourt Canton ou village Township or village Rang R'ge Bloc Block Lot Propriétaire Owner Taxes\tTaxes\t munie.\t8CO.\t \u2014\t\u2014\tTotal Munie.\tSchool\t taxes\ttaxes\t S 4.58\tS 42.02\tS 46.60 21.69\t150.18\t171.87 2.95\t17.65\t20.60 15.45\t104.27\t119.72 32.16\t64.80\t96.69 18.22\t27.66\t45.88 20.90\t50.09\t76.99 8.53\t19.60\t28.13 17.91\t50.03\t67.94 6.30\t12.30\t18.26 17.22\t117.56\t134.78 4.87\t41.06\t45.93 4.05\t14.87\t18.92 17.68\t56.09\t73.77 19.59\t81.25\t100.84 30.13\t178.31\t208.44 10.53\t53.67\t70.10 10.89\t67.56\t78.45 21.38\t40.20\t61.58 17.45\t28.96\t46.41 19.93\t84.21\t106.14 2.35\t8.25\t10.60 7.88\t11.14\t19.02 8.22\t17.05\t25.27 8.00\t15.02\t23.02 7.60\t38.18\t45.78 9.02\t43.27\t52.89 3.06\t15.01\t18.07 13.25\t95.73\t108.98 7.00\t19.70\t26.70 21.34\t82.25\t103.59 6.65\t25.71\t32.36 6.65\t25.59\t32.24 35.77\t90.53\t126.30 9.95\t4.00\t13.95 40.43\t20.11\t60.54 Carpentier.Courville.Senneterre Courville.:\u2022} 51-A-B .54.P.S.61-A-B & 62-A-B.50.64.55.50., 58.67.58-1-2-3-4.61.62.34-1-2.35-1-2.51-1-2-3-4.53-1-2-3-4- .55-1-2-3-4.P.S.60 .61-1-2.62-1-2.60.34-1-2.35-1-2.36-1-2.37-1-2.38-1-2.52.57.6H.5.6.9.7.44-1-2.45-1-2.Ci mklias Labbé.Emery Desputeau.Georges Otis.Laurenzo Belisle.Nestor Biais.Arthur Bouchard.I/'c Lavergne.Léo Lavergne.Lucien Bel an d.Nestor Biais.Raoul Roy.Raoul Roy., Lucien Raymond.Charles Pratte.Philippe Vilandré.Nelson Belisle.Maurice Lavoie.Sylva St-Amant.Alexandre Lauzé.Alexandre Lauzé.Société Coopérative Lucien Raymond.Charles Pratte.Léandre Lafrance.Alphée Richard Pascal Richard.Alphonse Petit.Emile Lacourse Jean-Louis Bacon.René Labonne.Joseph Bourgeoult.Joseph Bourgeault.Joseph Bourgeault .Georges Grosleau.Georges Cayer.Georges Cayer.Commission scolaire de Saint-Benoit de Laeorno \u2014 School Commission of Saint-Benoit de Laoorne \t4\t\t0.'.\t\t\t32.31\t32.31 \t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale de Sainte-Hélène \u2014 Municipal Corporation of Sainte-Hélène Commission scolaire de Sainte-Hélène \u2014 School Commission of Sainte-Hélène\t\t\t\t\t\t\t La Reine\t2\t\t59.\t\t4.42 4.38\t43.05 43.89\t47.47 48.27 T,a Sarrfl\t3\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Corporation de Saint-Jacques de Dupuy \u2014 Corporation of Saint-Jacques de Dupuy Commission scolaire de Dupuy \u2014 School Commission of Dupuy\t\t\t\t\t\t\t I n Hp] TIP\t4\t\t\t\t9.37 13.73\t37.69 37.49\t47.26 51.22 T~)pwmploi7PR\t3\t\t53.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t 1 716 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1951, Tome 88, N° 8 Canton ou\tRang\t\t\t\tTaxes\tTaxes\t village\t\tBloc\t\tPropriétaire\tmunie.\t8Cl0.\t _\t\u2014\t\u2014\tLot\t\u2014\t.\u2014\t-\tTotal Township or\tR'ge\tBlock\t\tOwner\tMunie.\tSchool\t villago\t\t\t\t\ttaxes\ttaxes\t \t10\t\t38.\t\t16.69 7.92 18.82 17.05 8.75 11.37 6.12 3.15 15.12 5.08 13.23\t38.75 17.50 65.55 65.10 20.00 26.25 80.41\t55.44 25.42 74.38 82.15 28.75 37.62 86.53 3.15 15.12 50.19 43.86 .in.\t\t\t40.\t\t\t\t \t1\t\t63.\t\t\t\t \t2\t\t25.\t\t\t\t i.10,060.00 Inspector's salaries.\u2022 5,200.00 Travelling expenses of inspectors.300.00 Board of examiners.,.500.00 Rent and lighting.1,600.00 Judicial and professional fees.2,650.00 Printing.-.525.00 Stationery.;.75.00 Equipment.40.00 * Meeting expenses.900.00 Postage, telephone and telegraph.650.00 Miscellaneous.;.500.00 $23,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 24, 1951.29553-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Bcrrctte, Minister of Labour, hereby gives notice that the \"Comité paritaire du Commerce de Farnham\",'district of Bedford, county of Missisquoi, established under decree number 123, of January 10, 1946, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.140 of February 8,1951, part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from the date of publication of the present by-law in the Quebec Official Gazette to January 19, 1952, it is laid in the following manner: a) The professional employers governed by the decree number 123 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 3^ of 1% of the fixed wages, bonuses and percentages paid to their employees subject to the said decree.b) All artisans governed by the said degree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of the minimum rates fixed by the decree for an employee in the same branch of the trade.c) All employees governed by the said decree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to \\4 of 1% °f their wages bonuses and percentage.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with report forms indicating the name of the firm, the name of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2#ht 1951, Vol.83, No.8 743 nom de l'établissement, le nom des salariés, les heures de travail, le taux du salaire, les montants payés ou payable et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire régulièrement tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même la rémunération de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et les faire parvenir audit Comité, en même temps que sa propre cotisation.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport accompagné des cotisations doit être adressé au Comité paritaire le ou avant le 10 de chaque mois.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective le Comité paritaire doit transmettre un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de Farnham, district de Bedford, comté de Missisiquoi, pour la période comprise entre le 19 janvier 1951 et le 19 janvier 1952.Comité paritaire du Commerce de Farnham, district de Bedford, comté de mlssisquoi Estimé des recettes et des déboursés pour la période comprise entre le 19 janvier 1951 et ' le 19 janvier 1952.Recettes: Cotisations (^del%): Employeurs professionnels.$250! 00 Artisans.75.00 Salariés.250.00 575.00 Déboursés: Salaire du secrétaire-gérant.-.275.00 Papeterie, poste et téléphone.25.00 Loyer de salle.20.00 Frais de cautionnement.5.00 Réception et déplacements.20.00 Vérification.5.00 Divers.155.00 Frais de perception.65.00 575.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 24 février 1951.29553-o employees, the hours of labour, the rate of wages, the amounts paid or payable and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall see to it that the reports be filled in and sent to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the sums payable to the Parity Committee, and forward same to the said committee together with his own assessments.The report of the professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The report, together with the assessments, shall be sent to the Parity Committee on or before the 10th day of each month.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report covering its financial operations and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the \"Comité paritaire du Commerce de Farnham\", district of Bedford, county of Missisquoi, for the period comprised between January 19, 1951, and January 19, 1952.Comité paritaire du Commerce de Farnham, district of Bedford county of Missisquoi Estimated receipts and expenditures for the period comprised between January 19, 1951, and January 19, 1952.Receipt?: Assessments of 1%): Professional employers.$250.00 Artisans.75.00 Employees.250.00 575.00 Expenditures: Secretary-manager's salary.275.00 Stationery, postage and telephone.25.00 Rent.20.00 Fidelity Bond.5.00 Receptioniind travelling expenses.20.00 Auditing.5.00 Miscellaneous.55.00 Collection expenses.65.00 575.00 GÉRARD TREMBLAY, t Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 24,1951.29553-0 Avis d'approbation de règlements Notice of Approval of By-Laws L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister Travail, donne avis par les présentes, conformé- of Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Loi de la convention provisions of the Collective Agreement Act (R.collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amende- S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that, ments), que, par l'arrêté en conseil numéro 172-D by Order in Council number 172-D of February du 15 février 1951, deux règlements spéciaux du 15, 1951, two spécial by-laws of the Building Comité conjoint des matériaux de construction, Materials Joint Committee, formed under decree établi en exécution du décret numéro 324 du 30 number 324 of March 30, 1950, and entrusted 744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2k février 1951, Tome 83, N° 8 mars 1950 et chargé de surveiller l'observance du with the administration of the decree number décret numéro 1256 du 16 novembre 1950, ont 1256 of November 16, 1950, bave been approved été approuvés et ajoutés à la constitution et aux and added to the constitution and general by-laws règlements généraux dudit Comité paritaire déjà of the said Joint Committee, already approved by approuvés par l'arrêté en conseil numéro 625-D Order in Council number 625-D of May 31, du 31 mai 1950.' 1950.En vertu de la Loi, les dispositions suivantes In pursuance of the terms of the Act, the follow-desdits règlements spéciaux ont été déclarés ing provisions of the said special by-laws have obligatoires.been rendered obligatory: \"Certificat de qualification: D'accord avec l'ar- \"Certificate of Competency: The Building tide 25 de la Loi de la convention collective, le Materials Joint Committee decides, in conformity Comité conjoint des matériaux de construction with section 25 of the Collective Agreement Act, décide de rendre le certificat de qualification that the certificate of competency be rendered obligatoire pour toute personne employée com- obligatory for any person engaged as Mechanic, me mécanicien, ajusteur, forgeron, monteur, aide Fitter, Blacksmith, Erector, Helper or Apprenti-ou apprenti dans la juridiction territoriale du ce in the territorial jurisdiction of decree No.décret numéro 1256 du 16 novembre 1950, relatif 1256 of November 16th, 1950, relating to the à l'industrie du fer et du-bronze ornemental, dont ornamental iron and bronze industry, which is il est chargé de surveiller et d'assurer l'observan.- administered by the said Committee, ce.Bureau d'Examinateurs: Les certificats de qua- Board of Examiners: Such certificate of com-lification seront émis par le bureau d'examina- petency shall be issued by the Board of Exami-teurs composé des représentants dûment nommés ners composed of the duly elected representatives sur le Comité du fer et du bronze.\" on the Iron and Bronze Committee.\" Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 24 février 1951.29553-o Quebec, February 24, 1951.29553-0 AVIS DE MODIFICATION NOTICE OF AMENDMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister of Travail, donne avis par les présentes, conformé- Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Loi de la convention provisions of the Collective Agreement Act (R.S.collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amende- Q.1941, chapter 163 and amendments), that the ments), que les parties contractantes à la conven- contracting parties to the collective labour agree- tion collective de travail relative à l'industrie de ment relating to the construction industry in the la construction dans les comtés de Joliette, Ber- counties of Joliette, Berthier, Montcalm and thier, Mcntcalm et l'Assomption, rendue obliga- L'Assomption, rendered obligatory by the decree toire par le décret numéro 1407 du 3 avril 1940 et number 1407 of April 3, 1940, and amendments, amendements, lui ont présenté une requête à have submitted to him a request to amend the l'effet de modifier ledit décret et ses amendements, said decree, and its amendments, as follows: de la façon suivante : 1° L'article III sera remplacé par le suivant: 1.Section III will be replaced by the following: \"HI.Taux de salaires: Les taux de salaires \"III.Rates of toages The following minimum minima suivants doivent être payés pour chacun rates of wages shall be paid for each one of the des métiers ci-après mentionnés: trades hereafter mentioned: Salaire horaire Hourly rates Métiers \u2014 Trades: Zones I II Ajusteur de gicleur \u2014 Sprinkler fitter.$1.25 $1.25 Briqueteur (compagnon) \u2014 Bricklayer (journeyman).1.25 1.25 Poseur de blocs et terra-cotta et tireur de joint \u2014 Block and terra-cotta layer and joint pointer.1.25 1.25 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.80 0.80 2ème année \u2014 2nd year.0.90 0.90 3ème année \u2014 3rd year.1.00 1.00 Brasseur de mortier \u2014 Mortar mixer.0.95 0.90 Brasseur de cé 1 an i te \u2014 Celanite mixer.0.95 0.90 Charpentier et menuisier (compagnon) \u2014 Carpenter and joiner (journeyman).1.25 1.15 Apprenti \u2014 Apprentice : 1ère année \u2014 1st year.0.70 0.65 2ème année \u2014 2nd year.0.75 0.70 3ème année \u2014 3rd year.0.85 0.80.4ème année \u2014 4th year.'.0.95 0.90 Calfat \u2014 Caulker.0.95 0.90 Couvreur d'amiante autre que les mécaniciens en isolément en tuyauterie \u2014 Asbestos coverer other than pipe insulation mechanics.1.25 1.15 Couvreur-ardoise, tuile \u2014 Roofer\u2014slate, tile.1.25 1.15 Couvreur\u2014composition, gravier, sable, asphalte \u2014 Roofer\u2014composition, gravel, sand, asphalt.1.25 1.15 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.\u201e\u2022.0.95 0.85 Charretier \u2014 Carter.#.0.90 0.85 Chauffeur (construction) \u2014 Fireman (construction) .1.05 1.00 Conducteur d§ monte-charge \u2014 Freight elevator operator.,.,.0.90 0.90 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2J,th, 1951, Vol.88, No.8 745 Métiers \u2014 Trades: Salaire horaire Hourly rates Zones i n Conducteur de tracteur \u2014 Tractor operator.1.10 1.10 Conducteur de rouleau compresseur (vapeur ou essence) \u2014 Roller operator (steam or gasoline).____ 1.05 1.05 Conducteur de \"Bulldozer\" \u2014 Bulldozer operator.1.05 1.05 Conducteur de nivelleuse \u2014 Grader operator.1.05 1.05 Électricien (compagnon) \u2014 Electrician (journeyman).1.30 1.25 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.70 0.65 2ème année \u2014 2nd year.0.75 0.70 3ème année \u2014 3rd year.0.85 0.75 4ème année \u2014 4th year.0.95 0.90 Ferblantier, couvreur (compagnon), ouvrier-tôlier, boutique ou chantier \u2014 Tinsmith, roofer (journeyman), sheet-metal worker shop or job.1.25 1.20 Apprenti \u2014 Apprence: 1ère année \u2014 1st year.0.65 0.60 2ème année \u2014 2nd year.0.75 0.65 3ème année \u2014 3rd year.0.85 0.80 Finisseur de ciment \u2014 Cement finisher.1.20 1.15 Finisseur de plancher en mastic \u2014 Mastic floor finisher.1.20 1.15 Foreur et poudrier \u2014 Drill operator and blaster.1.20 1.15 Forgeron sur chantier \u2014 Blacksmith on job.1.20 1.15 Journalier (ouvrier non qualifié) \u2014 Labourer (common worker).0.85 0.80 Homme de chaudière (boilerman) \u2014 Boilerman.0.85 0.80 Gratteur, polisseur et sableur de plancher \u2014 Floor scraping, polishing and sanding employees.1.25 1.15 Gréeur (à la main ou à la machine) \u2014 Rigger (hand or machine).1.25 1.15 Limeur de scie \u2014 Saw filer.1.25 1.20 Lettreur pour fins commerciales \u2014 Commercial letterer.1.35 1.35 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.75 0.75 2ème année \u2014 2nd year.0.80 0.80 3ème année \u2014 3rd year.0.95 0.©5 4ème année \u2014 4th year.1.05 1.05 Manœuvre, porteur de brique, bloc, mortier, terra-cotta, que ce soit à l'oiseau ou à la brouette, ou à la chaudière \u2014 Labourer, brick, block, mortar and terra-cotta carrier with hod, wheelbarrow or pail.0.95 0.90 Machiniste (millwright) \u2014 Millwright .-#.-#.1-25 1.15 Mécanicien en isolation de tuyauterie \u2014 Pipe insulation mechanic.1.25 1.15 Mécanicien de machine fixe ou mobile \u2014 Stationary or portable engineman.0.95 0.90 Machiniste \u2014 Machinist.:.0.95 0.90 Peintre-doreur \u2014 Painter-gilder.1.25 1.15 Peintre, aspergeur, décorateur, vitrier, poseur de papier-tenture et vernisseur de plancher (compagnon) \u2014 Painter, sprayman, decorator, glazier, paper hanger, floor vernisher (journeyman).1.10 1.00 Apprenti \u2014 Apprentice : 1ère année \u2014 1st year.0.70 0.65 2ème année \u2014 2nd year.0.75 0.70 3ème année \u2014 3rd year.0.80 0.75 4ème année \u2014 4th year.0.90 0.85 Plâtrier (compagnon) \u2014 Plasterer (journeyman).1.25 1.25 Apprenti \u2014 Apprentice : 1ère année \u2014 1st year.0.75 0.77 2èmé année \u2014 2nd year.0.85 0.85 3ème année \u2014 3rd year.v .»
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.