Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 mars 1951, samedi 17 (no 11)
[" Tome 83, N° 11 915 Vol.83, No.11 v\t\t \t\t *\t\t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act re»pecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 17 mars 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlement s _ 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frai* des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7e La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, March 17th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before* publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5*.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 916 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 88, N° 11 délai pour la réception des avis, documents où annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la [mblication de certains documents, à cause de leur ongueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.\u2022 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie 3ue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer1 is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 wards.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: - The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS, RÊDEMPTI PARADIS.King's Printer.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u2014 1-52 29088 \u2014 1-52 Lettres patentes Alexander Dworkin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre janvier 1951, constituant en corporation: Charles Brownstein, Melvin Salmon, avocats et Mary Steiman, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre et faire le commerce de toutes sortes de tissus et mrachandises en pièces et vêtements et accessoires, sous le nom de \"Alexander Dworkin Inc.\", avec un capital de $30,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Letters Patent Alexander Dworkin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, lettrers patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of January, 1951, incorporating Charles Brownstein, Melvin Salmon, advocates, and Mary Steiman, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To buy, sell and deal in all kinds of fabrics and piece goods, and wearing apparel and accessories, under the name of \"Alexander Dworkin Inc.\", with a capital stock of $30,000 divided into 500 common snares of the par value of $10 each, and 250 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1961, Vol.83, No.11 917 Bell Realties Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept .janvier 1951, constituant en corporation: William Jacob Colle, bourgeois, Mavis Grant et June Kirlin, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et disposer de biens immobiliers ou d'intérêts en iceux et de bâtisses ou autres constructions dessus érigées, sous le nom de \"Bell Realties Corporation\", 'avec un capital de $100,000 divisé en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 500actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur générai, le vingt-sept janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Bell Realties Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January, 1951, incorporating: William Jacob Colle, gentleman, Mavis Grant and June Kirlin, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in and dispose of real estate or interests therein, and buildings or other structures thereon erected, under the name of \"Bell Realties Corporation\", with a capital stock of.$100,000 divided into 500 preferred shares of a par value of $100 each, and 500 common shares having a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-0 Deputy Attorney General.Bickle-Seagrave (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq janvier 1951, constituant en corporation: Jean St-Germain, avocat, de West-mount, Claire Goyer, sténographe et Achille Raymond, comptable tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'appareils pour combattre et prévenir les incendies, de moteurs, automobiles et accessoires d'automobiles, sous le nom de \"Bickle-Seagrave (Quebec) Limited\", avec un capital de $500,000 divisé en $100,000 actions ordinaires de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Bijou Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première pactie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept janvier 1951, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, avocat, de la cité d'Outremont, Samuel Greenblatt,.avocat et Sonya Schnèyer, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands d'articles se rapportant à toutes sortes et genres d'objets pour la maison, sous le nom de \"Bijou Industries Ltd.\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur générât le vingt-sept janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Bickle-Seagrave (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January, 1951, incorporating.: Jean St-Germain, lawyer, of Westmount, Claire Goyer stenographer, and Achille Raymond, accountant both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montréal» for the following purposes : To deal in fire fighting and fire prevention equipment, motors, automobiles, automobile accessories, under the name of Bickle-Seagrave (Quebec) Limited\", with a capital stock of $500,000 divided into 100,000 common shares of $5 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of January, 1951.L.DÉSLLETS, 29652-o Deputy Attorney General.Bijou Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have, been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January, 1951, incorporating: Cyril E.Schwisberg, advocate, of the City of Outremont, Samuel Greenblatt, advocate, and Sonya Schneyer, secretary, both of the City of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in goods, with reference to all manners and types of household wares, under the name of \"Bijou Industries Ltd.\", with a capital stock of $30,000 divided into 300 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney general this twenty-seventh day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-o Deputy Attorney General. 918 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1961, Tome 83, N° 11 Edclene Jobbers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il.a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq janvier 1951, constituant en corporation: Samuel Alexander Shulman, avocat, Mortimer Weinfield, avocat et Beatrice Bonnell, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de machinerie et moteurs, d'installations commerciales pour magasins et restaurants, d'huileset graisses, quincaillerie, appareils électriques et faire le commerce de fourrures et vêtements, sous le nom de \"Edelene Jobbers, Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Edelene Jobbers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January, 1951, incorporating: Samuel Alexander Shulman, advocate, Mortimer Weinfield, advocate and Beatrice Bonnell, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in machinery and motors, commercial equipment for stores and restaurants, oils and greases, hardware, electrical appliances; and deal in furs and clothing, under the name of \"Edelene Jobbers, Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-0 Deputy Attorney General.Estate Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq janvier 1951, constituant en corporation: Max Coblentz, Samuel Royce Altrows, avocats, tous deux de la cité d'Outremont et Cladys Brocklehurst Watson, .sténographe, veuve de feu Everett Watson, de Verdun, tous lu district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de terrains et d'une agence d'immeubles et agir comme courtiers et estimateurs d'immeubles et comme agents d'assurances, sujet au consentement préalable du Surintendant des assurances de Québec, sous le nom de \"Estate Investments Ltd.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Jewish Ezra Convelescent Home Avis est donné qu'en vertu de la troisième ¦ partie de la Loi des compagnies de Québec,* il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 376, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-neuf janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions : Israël Rabinovitch, éditeur, Mordecai M.Peters, secrétaire, Pinches Kooperstock, marchand, Dame Gertie Frankel Kooperstock, ménagère, épouse de Pinches Kooperstock, Joe Remer, manufacturier, Dame Sara Frankel Lefcort, ménagère, veuve de feu Myer Lefcort, Pinkus Hirschprung, rabbin, et Lily Mann, teneuse de-livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Fonder, établir, aménager, entretenir et diriger une maison pour le soin des vieillards, des infirmes et des convalescents, sous le nom de \"Jewish Ezra Convalescent Homes\".Estate Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January, 1951, incorporating: Max Coblentz, Samuel Royce Altrows, advocates, both of the City of Outremont, and Gladys Brocklehurst Watson, stenographer, widow of the late Everett Watson, of Verdun, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and land company and a real estate agency, and to act as real estate brokers and valuators, and as insurance agents, subject to the previous consent of the Superintendent of Insurance of Quebec, under the name of \"Estate Investments Ltd.\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of January, 1951.L.DÉSDLETS, 29652-o Deputy Attorney General.Jewish Ezra Convelescent Home * Notice is hereby given that under the provisions of Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-ninth day of January, 1951, incorporating without share capital: Israël Rabinovitch, editor, Mordecai M.Peters, Secretary,' Pinches Kooperstock, merchant, Dame Gertie Frankel Kooperstock, housewife, wife of Pinches Kooperstock, Joe Remer, manufacturer, Dame Sarah Frankel Lefcort, housewife, widow of the late Myer Lefcort, Rabbi Pinkus Hirschprung, Rabbi, and Lily Mann, bookkeper, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To found, establish, equip, maintain and operate a home for the care of the aged, infirm and convalescents, under the name of \"Jewish Ezra Convalescent Home\".# QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 919 Le montant est .limitée la valeur dès biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Jimmy's Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre janvier 1951; constituant en corporation: Albert Saurault, inspecteur, René Cou-sineau, secrétaire et Vincent Soccio, restaurateur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'un restaurant, sous le nom de \"Jimmy's Restaurant Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.Mark Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du trente janvier 1951, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi du Roi, de Westmount, Theo.lore Herzl Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal et Jean McFarlane, dactylographe, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Mark Corporation\", avec un capital de $50,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $100,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of January, 1951.L.DÊSILETS, \u2022 29652-0 Deputy Attorney General.Jimmy's Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of January, 1951, incorporating: Albert Saurault, inspector, René Cousineau, secretary, and Vincent Soccio, restauranteur, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Jimmy's Restaurant Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 500 common shares of the Par value of $10.each, and 1,400 preferred shares at the par valueof $25 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of January, 1951.L.DESILETS, 29652-0 Deputy Attorney General.Mark Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirtieth day of January, 1951, incorporating: Benjamin Robinson, advocate and King's Counsel, of Westmount, Theodore Herzl Shapiro, advocate, of the Town of Mount Royal, and Jean McFarlane typist, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of an investment company, under the name of \"Mark Corporation\", with a capital stock of $50,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each, and 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of January, 1951.L.DÉSIXETS, ' 29652-0 Deputy Attorney General.Midtown Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des\" lettres patentes en date du vingt-cinq janvier 1951, constituant en corporation: Isidore M.Bobrove, avocat, David Love; comptable et Ruth Budyk, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants.: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Midtown Realty Corporation\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de Midtown Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of th« Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January, 1951, incorporating: Isidore M.Bobrove, advocate, David Love, accountant and Ruth Budyk, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate company, under the name of \"Miltown Realty Corporation\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of a par value 920 GAZETTE OFFICIELLE DE QJjÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 83, N° 11 $100 chacune et en 200 action privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq janvier 1951.« L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.M.Schleien Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre janvier 1951, constituant en corporation: Charles Wolfson, avocat, Alva P.Boyd, sténographe, tous deux de la cité de Montréal et Cyril E.Schwisberg, avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter et diriger des magasins de détail pour la vente d'habits, vêtements et accessoires, sous le nom de \"M.Schleien Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.of $100 each, and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-o Deputy Attorney General.M.Schleien Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of January, 1951, incorporating: Charles Wolfson, advocate, Alva P.Boyd, stenographer, both of the City of Montreal, and Cyril E.Schwisberg.adovcate, of the city \\ of Outre-mont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate and conduct retail stores for the sale of clothing, wearing apparel and accessories, under the name of \"M.Schleien Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of January, 1951.L.DÊSILETS, 296n2-o Deputy Attorney General.Stonete Corporation Ltd.Stonete Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov-province de Québec, des lettres patentes en date ince of Quebec, bearing date the twenty-fourth du vingt-quatre janvier 1951, constituant en day of January, 1951, incorporating: ¦ Lovel corporation: Lovell Caverhill Carroll, conseil Caverhill Carroll, King's Counsellor, John Bum-en loi du Roi, John Bumbray, conseil en loi du bray, King's Counsellor, of the Town of Mount Roi de ville Mont-Royal, Jean-Paul Cardinal, Royal, Jean-Paul Cardinal, advocate, Jehan avocat, Jehan Perdirau, avocat et Françoise Perdriau, advocate, and Françoise Caisse, secre-Caisse, secrétaire, tous trois de la cité de Mont-\" tary, all three of the City of Montreal, all in the real, tous du district judiciaire de Montréal, pour Judicial District of Montreal, for the following les objets suivants: purposes: Exercer le commercé d'immeubles et celui qui To carry on a real estate, building and contrac- consiste à construire et bâtir-dans toutes ses ting business in all its branches, under the name of spécialités, sous le nom de \"Stonete Corpora- \"Stonete Corporation Ltd.\", with a capital stock tion Ltd.\", avec un capital de $15,000 divisé en of $15,000.divided into 15,000 shares of $1.each.15,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the Company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General vingt-quatre janvier 1951.twenty-fourth day of January, 1951.VAssistant-procureur général, L.DÉSLLETS, 29652 L.DÊSILETS.29652-0 Deputy Attorney General.Unie Steel Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Çoverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six janvier 1951, constituant en corporation: Joseph S.C api an, Murray Lapin, avocats et Harry Golden, huissier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'aucune sorte de métal, bois, acier, verre ou plastique ou articles qui contiennent principalement ces maté' riaux, sous le nom de \"Unie Steel Products Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune Unie Steel Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January, 1951, incorporating: Joseph S.Caplan, Murray Lapin, advocates, and Harry Golden, bailiff, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal with any kind of metal, wood, steel, glass or plastic or articles which principally contain, these materials, under the name of \"Unie Steel Products Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 100 common shares having a par value of $100.each, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1961, Vol.83, No.11 921 et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune., Le siège social de la compagie sera à Ville Jacques Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS William Paterson & Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept janvier 1951, constituant en corporation: Seymour Elkin, notaire, de la cité de Westmount, Stanley St anger, officier d'une compagnie de fiducie, de la ville de Hampstead et Ralph C.Tees, officer d'une compagnie de fiducie, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer, négocier, faire le commerce et ouvrer toutes sortes de métaux, y compris le travail qui consiste à finir le bronze dans» toutes ses spécialités, fondre le bronze et forger l'étain et le cuivre sous le nom de \"William Paterson & Company Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6940 avenue Park, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS, Harvue Extension Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix-sept février 1951, constituant en corporation: Isabelle Lemay, Pauline Cabana et Gisèle Grondin, sténographes, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Bar-vue Extension Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu (d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1951.L*Assistant-procureur général, 29652 L.DÊSILETS.and 300 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Ville Jacques Cartier, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-o Deputy Attorney General.William Paterson & Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January, 1951, incorporating: Seymour Elkin, notary, of the City of West-mount, Stanley Stanger, trust company officer, of the Town of Hampstead, and Ralph C.Tees, trust company officer, of the City of Westmount, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing, trading and dealing in and installing all kinds of metals, including the work of brass finishing in all its branches, brass founding, tin and copper smithing, under the name of \"William Paterson & Company Inc.\", with a capital stock of $20,000.divided into 2,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at 6940 Park Avenue, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of January, 1951.L.DÊSILETS, 29652-o Deputy Attorney General.Barvue Extension Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth day of February, 1951, incorporating: Isabelle Lemay, Pauline Cabana and Gisèle Grondin, stenographers, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Barvue Extension Ltd.\" (No Personal Liabilitv)\", with a capital stock of $4,000,000.divided into 4,000,000 shares of $1.each.The shareholders will incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will bs at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29652-0 Deputy Attorney General. \\ Hart Shirt Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-neuf janvier 1951, constituant en corporation: Jos.Hart, employé civil, René Hart, industriel, et Paul Hart, technicien, tous trois des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants : Exercer l'industrie de la fabrication et le commerce de chemises, de vêtements et hardes de toutes sortes et espèces, sous le nom de \"Hart Shirt Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29652-0 L.DÊSILETS.Hart Shirt Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters\"patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-ninth day of January, L951, incorporating: Jos.Hart, civil employee, René Hart, industrialist, and Paul Hart, technician, all three of the city and Judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in shirts, wearing apparel and garments of all kinds and descriptions, under the name of \"Hart Shirt Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of January, 1951.\u2022 L.DÊSILETS, 29652 Deputy Attorney General.Dupas Metals Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze février 1951, constituant en corporation: Pauline Cabana, Isabelle Lemay et Cordelia Leclerc, sténographes, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais; * Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Dupas Metals Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29682 L.DÊSILETS.Dupas Metals Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of February, 1951, incorporating: Pauline Cabana, Isabelle Lemay and Cordelia Leclerc, stenographer, of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals: Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated,-in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Dupas Metals Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4,000,000.divided into 4,000,000 shares of $1.each.The shareholders will incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29682-0 Deputy Attorney General.H.Langevin Lumber Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.Alfred lorisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt février 1951, constituant en corporation: Georges-A.Langevin, marchand, de Car-tierville, Jean-Paul Lavallée, avocat, et Andrée H.Langevin Lumber Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of February, 1951, incorporating: Georges A.Langevin, merchant, of Cartierville, Jean Paul Lavallée, advocate, and Andrée Patenaude, 922 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 83, N° 11 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 923 Patenaude, sténographe, ces deux derniers de la Cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie du bois sous toutes ses formes y compris ses sous-produits, sous le nom de \"H.Langevin Lumber r * j6»'» avec un capital de $125,000 divisé en 1250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cartier-ville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt février 1951.L'Assistant-procureur général, 29682-o L.DÊSILETS.Avis de correction Ferland & Marier Ltée Avis est donné que l'avis concernant l'octroi de lettres patentes à la compagnie ci-haut mentionnée, tel que publié dans la Gazette officielle de Québec, tome 83, N° 9, du 3 mars 1951, page 775, est corrigé de la façon suivante: partout où ils apparaissent dans ledit avis, les mots \"district judiciaire de Bedford\" sont remplacés par les mots \"district judiciaire de Joliette\".Daté du bureau du Procureur général, le 13 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 29682-0 L.DÊSILETS.stenographer, these two latter of the City of Montreal, all of the judicial district of Mont-treal, for the following purposes: To carry on the lumber business and deal in lumber in all forms of same including its byproducts, under the name of \"H.Langevin Lumber £td*\" w*th a capital stock of $125,000 divided into 1250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Cartierville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29682 Deputy Attorney General.Notice of Correction Ferland & Marier Ltée Notice is given that the notice of the issue of letters patent to the above mentioned company, as published in the Quebec Official Gazette, Volume 83, No.9, of March 3, 1951, page 775 is corrected in the following manner: every place where they appear in said notice, the words \"judicial district of Bedford\" are replaced by the words \"judicial district of Joliette\".Dated at the office of the Attorney General, this 13th of March, 1951.L.DÊSILETS, 29682 y Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Biron-Knitting Mills Ltd.La Cie de Tricots Biron Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 février 1951, à la Compagnie \"Biron-Knitting Mills Ltd.\u2014 La Cie de Tricots Biron Ltée\" ratifiant son règlement \"BB\" augmentant son capital actions autorisé de $99,000 à $200,000 par la création de 1,010 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 14 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691-0 L.DÊSILETS.Canada Flushwood Door Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 février 1951, à la compagnie \"Canada Flushwood Door Limited\", ratifiant son règlement N° 5t 1° subdivisant 1,490 actions ordinaires de $10 en 14,900 actions ordinaires de $1 chacune; 2° créant 35,000 actions ordinaires additionnelles de $1 chacune; 3° créant 5,000 actions privilégiées classe \"A de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement; 4° modifiant la classe, les privilèges, droits, restrictions et limitations attachés aux actions créées par les lettres patentes supplémentaires du 17 août 1932.Biron-Knitting Mills Ltd.La Cie de Tricots Biron Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the fourteenth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Biron Knitting Mills Ltd.\u2014 La Cie de Tricots Biron Ltée\", ratifying its By-law \"BB\" increasing its authorized capital stock from $99,000 to $200,000 by the creation of 1,010 additional preferred shares of $100 each, carrying in the same rights, restrictions and privileges as set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1951: L.DÊSILETS, 29691 Deputy Attorney General.Canada Flushwood Door Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary lettters patent bearing date the twenty-sixth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"Canada Flushwood Door Limited\" ratifying its By-law No.5:1.Subdividing 1,490 common shares of $10 each into 14,900 common shares of $1 each; 2.creating 35,000 additional common shares of $1 each; 3.creating 5,000 Class A preferred shares of $100 each, subject to the privileges, restrictions mentioned in said By-law; 4.amending the class, privileges, rights, restrictions and limitations attaching to the shares created by the supplementary letters patent of August\"]17, 1932. 924 GAZETTE OFFICIELLE DE QVÊB V, Québec, 17 mars 1951, Tome 88, N° 11 Daté du bureau du Procureur général, le 26 Dated at the office of the Attorney General, février 1951.this twenty-sixth day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÊSILETS, 29691-0 L.DÊSILETS.29691 Deputy Attorney General.Chez Donald Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 17 février 1951, à la compagnie \"Gascon Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 avril 1932, ratifiant son règlement No.4: a) changeant son nom en celui de \"Chez Donald Ltée\"; b) augmentant son capital autorisé de $10,500 à $50,000 par la création de 395 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 17 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Chez Donald Ltée.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Gascon Limitée\", incorporated by letters patent dated April 20th, 1932, ratifying its By-law No.4: a) changing its name to that of \"Chez Donald Ltée\"; 6) increasing its authorized capital stock from $10,500 to $50,000 by the creation of 395 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 17th day of Fabruary, 1951.L.DÊSDLETS, 29691-0 Deputy Attorney General.Ciment Québec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Lci des compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 15 février 1951, à la compagnie \"Les Industries Calcaires Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes du 19 mai 1948, sous le nom originaire de \"Les Laboratoires Pagnol Inc.\u2014Pagnol Laboratories Inc\".et par lettres patentes supplémentaires du 25 février 1949, changeant, inter alia, le nom originaire de la compagnie en celui de \"Les Indus tries Calcaires Inc.\", et par de nouvelles lettres patentes supplémentaires en date respectivement des 6 avril 1949 et 30 juin 1950, ratifiant son règlement numéro VHI: a) changeant de nouveau le nom de ladite compagnie en celui de \"Ciment Québec Inc.\"; b) subdivisant ses 16,000 actions ordinaires sans valeur au pair en 32,000 actions ordinaires sans valeur au pair; c) augmentant le capital-actions de la compagnie par la création de 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair additionnelles et de 10,000 actions privilégiées additionnelles de $50 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement; d) fixant à $273,500 le montant avec lequel la compagnie pourra continuer ses opérations; e) abrogeant une disposition des lettres patentes concernant le transfert des actions.Daté du bureau du Procureur général, le 15 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691-o L.DÊSILETS.Ciment Québec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec- Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the fifteenth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Industries Calcaires Inc.\" incorporated by letters patent dated May 19, 1948, under the original name of \"Les Laboratoires Pagnol Inc.\u2014Pagnol Laboratories Inc.\" and by supplementary letters patent dated February 25, 1949, changing inter alia the original name of the company to that of \"Les Industries Calcaires Inc.\" and by new supplementary letters patent dated respectively April 6,1949 and June 30, 1950, ratifying its By-law No.VIII: a) Again changing the name of the said company into that of \"Ciment Québec, Inc.\"; b) subdividing its 16,000 common shares without par value into 32,000 common shares without par value; c) increasing the capital stock of the company by the creation of 2,000 additional common shares without par value and 10,000 additional preferred shares of $50 each, carrying the rights, restrictions and privileges set forth in the said by-law; d) fixing to $273,500 the amount with which the company may continue its operations; e) repealing a provisions of the letters patent concerning the transfer of shares.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691 Deputy Attorney General.Cinq-0 Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 février 1951, à la compagnie \"Les Industries Cinq-0 Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes datée du 13 décembre 1945, ratifiant son règlement: 1° changeant son nom en celui de \"Cinq-0 Ltée\"; 2° portant son capital-actions de $6,000 à $40,000 par la création de 1,900 actions ordinaires additionnelles de $10 chacune et 1,500 Cinq-0 Ltée \u2014 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the twenty-first day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Industries Cinq-0 Ltée\", incorporated by letters patent dated December 13, 1945, ratifying its By-law: 1.Changing its name to that of \"Cinq-0 Ltée; 2.Increasing its capital stock from $6,000 to $40,000, by the creation of 1,900 aditional common shares of $10 each, and 1,500 preferred shares of $10 each, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1961, Vol.88, No.11 925 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux subject to the privileges and restrictions men-privilèges et restrictions mentionnés audit re- tinned in the said-By-law.glement.* .Daté du bureau du Procureur général, le 21 Dated at the office of the Attorney General, février 1951- > this twenty-fust day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÊSILETS, 29691-q L.DÊSILETS.29691 Deputy Attorney General.Cumming-Perrault Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 16 février 1951, à la compagnie \"Cumming-Perrault Limited\", ratifiant son règlement spécial \"C\" diminuant son capital de $520,000 à $201,800 par l'annulation de 3,182 actions privilégiées rachetées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 16 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Empire Electroplating Works Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 26 février 1951, à la compagnie \"Empire Glass Works Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 avril 1945, changeant son nom en celui de \"Empire Electroplating Works Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 26 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Cumming-Perrault Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Cumming-Perrault Limited\", ratifying its Special By-law \"C\" reducing its capital stock from $520,000 to $201,800 by the cancellation of 3,182 redeemed preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this 16th day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691-0 Deputy Attorney General.Empire Electroplating Works Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Empire Glass Works Ltd.\", incorporated by letters patent dated April 12, 1945, changing its name to that of \"Empire Electroplating Works Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this 26th day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691-o Deputy Attorney General.Forden-Crescent Shirts Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 22 février 1951, à la compagnie \"Forden-Crescent Shirts Ltd.\", ratifiant son règlement \"A\", augmentant son capital de $20,000 à $100,000 par la création de 800 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 22 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Forden-Crescent Shirts Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Forden-Crescent Shirts Ltd.\", ratifying its By-Law \"A\" increasing its capital stock of $20,000 to $100,000 by the creation of 800 preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 22nd day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691-o Deputy Attorney General.Gordon Belt & Novelty Company Ltd.Gordon Belt & Novelty Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 14 février 1951, à la compagnie \"Lou Gordon Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 novembre 1950, changeant son nom en celui de \"Gordon Belt & Novelty Company Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 14 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 DÊSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Lou Gordon Ltd.\", incorporated by letters patent dated November 10,1950, changing its.name to that of \"Gordon Belt & Novelty Company Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this 14th day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29601-o Deputy Attorney General. 926 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1961, Tome 83, N° 11 John F.Wickenden Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 février 1951, à la compagnie \"John F.Wickenden Company Limited\", ratifiant son règlement No 24, augmentant son capital de $20,000 à $170,000 par la création de 15,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 19 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Lemo Shops Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 23 février 1951, à la compagnie \"Lemo Shops Inc.\", ratifiant son règlement No 24, augmentant son capital de $20,000 à $200,000 par la création de 600 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune et de 1,200 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés.audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 23 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Marvel Headwear Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 27 février 1951, à la compagnie \"Led-Mil Mfg.Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 novembre 1949, changeant son nom en celui de \"Marvel Headwear Ltd.\" * Daté du bureau du Procureur général, le 27 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Matteau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 17 février 1951, à la compagnie \"Matteau Limitée\", ratifiant son règlement No 6 augmentant son capital de $49,000 à $99,000 par la création de 500 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 17 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29091-o L.DÊSILETS.Purity Bakery Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 16 février 1951, à la com- John F.Wickenden Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day Of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"John F.Wickenden Company Limited\", ratifying its By-Law No.24 increasing its capital stock from $20,000 to $170,000 by the creation of 15,000 preferred shares of $10 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 19th day of February, 1951.L.DÊSILETS, 2969 l-o Deputy Attorney General.¦ \u2022 - \" - i Lemo Shops Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company 'Xemo Shops Inc.\", ratifying its By-Law No.24 increasing its capital stock from $20,000 to $200,000 by the creation of 600 additional common shares of $100 each and 1,200 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 23rd day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691-o Deputy Attorney General.Marvel Headwear Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Led-Mil Mfg.Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated November 9th, 1949, changing its name to that- of \"Marvel Headwear Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this 27th day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691-o Deputy Attorney General.Matteau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters p&tent bearing date the seventeenth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Matteau Limitée\" ratifying its By-law No.6, increasing its capital stock from $49,000 to $99,000 by the creation of 500 preferred shares of $100 each, carrying the rights, restrictions, and privileges set forth in said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29691 Deputy Attorney General.Purity Bakery Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of February, 1951, were issued by the Lieutennat-Governor of the Province of Quebec, to the company _QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1961, Vol.88, No.11 927 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 27 février 1951, à la compagnie \"London Felt Mfg.Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettrés patentes en date du 12 décembre 1944, changeant son nom en celui de \"Remer Spring Mfg.Co.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 27 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Simard, Chevalier & Choyer Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 février 1951, à la compagnie 'Judsôn G.Lee & Sons Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 juin 1933, changeaut son nom en celui de \"Simard, Chevalier & Choyer Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 24 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29691 L.DÊSILETS.Empire Clothing Manufacturing Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"London Felt Mfg.Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated December 12, 1944, changing its name to that of \"Remer Spring Mfg.Co.Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this 27th day of February.1951.L.DÊSILETS, 29691-o Deputy Attorney General.Simard, Chevalier & Choyer Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Judson G.Lee & Sons Limited\", incorporated by letters patent dated June 30, 1933, changing its name to that of Simard-Chevalier & Choyer Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of February, 1951.^ L.DÊSILETS, 29691-6 ' Deputy Attorney General.Empire Clothing Manufacturing Company Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la letters patent, bearing date the 17th day of province de Québec, des lettres patentes sup- February, 1951, were issued by the Lieutenant- plémentaires en date du 17 février 1951, à la Governor of the Province of Quebec, to the com- compagnie \"Empire Clothing Manufacturing pany \"Empire Clothing Manufacturing ,Com- Company\", ratifiant son règlement N° 32, aug- panv\", ratifying its By-law No.32 increasing mentant son capital de $99,000 à $299,000 par its capital from $99,000 to $299,000 by the la création de 40,000 actions privilégiées de $5 creation of 40,000 preferred shares of $5 each, chacune sujettes aux droits, restrictions et privi- subject to the rights, restrictions and privileges lèges énumérés audit règlement.enumerated in the said By-law.Daté du bureau du Procureur général, le 17 Dated at the office of the Attorney General, février 1951.this 17th day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, , L.DÊSILETS, 29694 L.DÊSILETS.29694-o Deputy Attorney General.J.J.Shea & Company Limited J.J.Shea & Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary été accordé\"par le Lieutenant-gouverneur de la letters patent, bearing date the 23rd day of province de Québec, représenté par M.Alfred February, 1951, were issued by the Lieutenant- Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Governor of the Province of Quebec, reprensented Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres pa- by Mr.Alfred Morisset, in conformity with tentes supplémentaires en date du 23 février section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 1951, à la compagnie \"J.J.Shea & Company 276, to the company \"J.J.Shea & Company Limited\", ratifiant son règlement \"CC\" aug- Limited\", ratifying its By-law \"CC\" increasing mentant son capital de $20,000 à $100,000 par its capital stock from $20,000 to $100,000 by la création de 800 actions privilégiées de $100 the creation of 800 preferred shares of $100 chacune, sujettes aux droits, restrictions et privi- each, subject to the rights, restrictions and lèges énumérés audit règlement.privileges enumerated in the said by-law.Daté du bureau du Procureur général, le 23 Dated at the office of the -Attorney General, février 1951.this 23rd day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÊSILETS, 29694 L.DÊSILETS.29694-o Deputy Attorney General.pagnie \"Purity Bakery Limited\", ratifiant son \"Purity Bakery Limited\", ratifying its By-Law règlement N° 29, augmentant son capital de No.29 increasing its capital stock from $40,000 $40,000 à $390,000 par la création de 3,500 actions to $390,000 by the creation of 3,500 preferred privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privi- shares of $100 each, subject to the privileges and lèges et restrictions mentionnés audit règlement, restrictions mentioned in the said by-law.Daté du bureau du Procureur général, le 16 Dated at the office of the Attorney General, février 1951., this 16th day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÊSILETS, 29691 L.DÊSILETS.29691-0 Deputy Attorney General.Remer Spring Mfg.Co.Ltd.Remer Spring Mfg.Co.Ltd. 928 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 83, N° 11 Merchants Press Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 26 février 1951, à la compagnie \"Mercliants Press Limited\", ratifiant son règlement N° \"A\", augmentant son capital de $1,000 à $40,000 par la création de 900 actions ordinaires additionnelles de $10 chacune et de 300 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 26 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29694 L.DÊSILETS.Parco Drilling & Exploration Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 février 1951, à la compagnie \"Parco Drilling & Exploration Company Limited\", ratifiant son règlement portant son capital-actions de $20,000 à $50,000 par la création de 1,200 actions additionnelles dé $25.Daté du bureau du Procureur général, le 23 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29694-o L.DÊSILETS.Merchants Press Limited Notice is hereby given that under Part I of the \u2022.Quebec Companie ' Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Merchants Press Limited\", ratifying its By-law No.\"A\" increasing its capital from $1,000 to $40,000 by the creation of 900 additional common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100.each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 26th day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29694-o Deputy Attorney General.Parco Drilling & Exploration Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the twenty-third day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Parco Drilling & Exploration Company Limited\", ratifying its by-law increasing its capital stock from $20,000 to $50,000 by the creation of 1,200 additional shares of $25.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29694 Deputy Attorney General.Standard Auto Supply Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 février 1951, à la compagnie \"Standard Auto Supply Limited\", ratifiant son règlement N° 30 portant son capital-actions de $20,000 à $70,000 par la création de 500 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux privilèges et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 20 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29694-o L.DÊSILETS.Standard Auto Supply Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing the twentieth day of February, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Standard Auto Supply Limited\" ratifying its By-law No.30 increasing its capital stock, from $20,000 to $70,000, by the creation of 500 preferred shares of $100 each, subject to the privileges and restrictions mentioned in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of February, 1951.L.DÊSILETS, 29694 Deputy Attorney General.Avis divers Miscellaneous Notices AVIS DE CHANGEMENT DE NOM NOTICE OF CHANGE OF NAME (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicates' Act).Avis est donné que l'honorable Secrétaire de Notice is given that the Honourable the \u2022la province a autorisé, le 9 mars 1951, le chan- Provincial Secretary authorized, under date the gement de nom de \"L'Association des Gardes 9th of March, 1951, the change of name of Malades Graduées de l'Hôpital Ste-Justine\" en \"L'Association des Gardes Malades Graduées celui de \"Association des Infirmières de l'Hô- de l'Hôpital Ste-Justine\" into that of \"Asso-pital Sainte-Justine\", et ce, conformément.aux dation des Infirmières de l'Hôpital Sainte-Jus-dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats tine\", and such, pursuant to the provisions of professionnels.section 7 of the Professional Syndicates' Act.Donné au bureau du Secrétaire de la province Given at the office of the Provincial Secretary, le 10 mars 1951.this tenth day of March, 1951.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHÉSI, 29653-o JEAN BRUCHÉSI.29653 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.88, No.11 929 Avis de changement de la date de presentation des candidats et de la date des elections' générales.Avis est, par les présentes, donné que la ville de- Mackayville, en conformité de l'article 173 de la Loi des cités et villes, présentera au Lieutenant-gouverneur en conseil, une requête pour changer la date de la présentation des candidats et la date des élections générales.A une assemblée Spéciale des membres du Conseil municipal de la corporation de la ville de Mackayville, tenue le 27 février 1951, le soussigné, secrétaire-trésorier, a été requis de préparer les formalités nécessaires pour changer la date des élections comme suit: la date de la présentation des candidats ainsi que celle des élections générales, qui ' sont actuellement fixées respectivement au 25 janvier ou au premier jour juridique suivant, et au premier jour juridique de mai, seront à l'avenir fixées respectivement au 26 avril, pour la présentation des candidats, et si ce jour est férié, au premier jour juridique suivant; et au 2 mai, pour les élections générales, et si ce jour est férié, au premier jour juridique suivant.La requête sera présentée après la publication des avis ordonnés par la loi.Mackayville, le 27e jour de février 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29613-10-4-o ROLAND BARBEAU.Canada Envelope Company Règlement spécial \"28\" Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un** règlement de la compagnie \"Canada Envelope Company\" ce qui suit 1.Que le nombre des directeurs de.la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de dix (10) à neuf (9) de manière à ce que le bureau de direction de la compapnie soit dorénavant composé de neuf (9) directeurs.2.Cinq (5) directeurs constitueront un quorum à toute assemblée du bureau de direction.3.Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés modifiés et revisés afin de donner effet au présent règlement.Décrété le trente janvier 1951.(Sceau) Le Président, G.R.THOMSON.Le Secrétaire, 29654 M.M.FORSYTH.Laiterie City Dairy Ltd.Extrait du procès-verbal de l'assemblée annuelle des actionnaires de \"Laiterie City Dairy s Ltd.\", tenue le 14 novembre 1950, concernant la réduction du nombre des directeurs de sept à cinq.\"Sur proposition dûment secondée, il est résolu que la première ligne de l'article 8 du règlement N° 1 de la compagnie soit rayée et remplacée par là suite: \"Les affaires de la compagnie seront conduites par cinq directeurs.\" Québec, 15 novembre 1950.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 29656-o WILBROD BHERER.Notice of change of Date of Nominations of Candidates and Date of General Elections.Notice is hereby given that the Town of Mackayville, in conformity with section 173 of the Cities and Towns' Act, will submit to the Lieutenant-Governor in Council, a petition to change the date of nominations of candidates and the date of General elections.At a special meeting of the members of the Municipal Council of the Corporation of the Town of Mackayville, held on the 27th of February 1951, the undersigned, secretary-treasurer, was requested to prepare the formalities required to change the date for the elections as follows: the date for the nomination of candidates and also that of the general elections, actually fixed respectively to the 25th of January or first juridical day following, and to the first juridical day of May, shall for the future, be fixed respectively to the 26th of April, for the nomination of candidates and if this day be a holiday, to the first following juridical day; and to the 2nd of May for the general elections and if this day be a holiday, to the first juridical day following same.The petition will be presented after, publication of the notices required by law.Mackayville, February 27th, 1951.ROLAND BARBEAU, 29613-10-4-o Secretary-Treasurer.Canada Envelope Company Special By-law \"28\" Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"Canada Envelope Company\", as follows: 1.The number of directors of the Company be and the same is hereby decreased from ten (10) to nine (9), so that the board of directors of the Company shall hereafter be composed of nine (9) directors.2.Five (5) directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to the present by-law.Enacted this thirtieth day of January, 1951.(Seal) G.R.THOMSON, v President.M.M.FORSYTH, 29654-o Secretary.Laiterie City Dairy Ltd.Excerpt from the minutes of the annual meeting of the shareholders of \"Laiterie City Dairy Ltd.\", held on the 14th of November, 1950, concerning the decrease in the number of directors from seven to five.\"Upon motion duly seconded, it was resolved that the first line of Article 8 of By-law No.1 of the company be struck out and replaced by the following: \"The affairs of the company will be managed by five directors\".Quebec, November 15, 1950.Certified true copy.WILBROD BHERER, 29656 Secretary. 930 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 83, N° 11 Avis est donné que, sur la recommandation Notice is hereby given that, upon the recom- de PAssistant-procureur général, et conformé- mendation of the Deputy Attorney General, ment aux dispositions de l'article 225 de la Loi and pursuant to the provisions of section 225 Loi des compagnies de Québec, les règlements of the Quebec Companies' Act, By-laws Nos Nos un et deux de \"Gatineau Memorial Hospital, One and Two of \"Gatineau Memorial Hospital, Wakefield\", tels qu'adoptés le 23 octobre 1950, Wakefiled\", as adopted on October 23rd, 1950, ont été approuvés par l'Honorable Secrétaire were approved by the Honourable the Provincial dc la Province en date du 2 mars 1951.Secretary on the 2nd day of March, 1951.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, Given at the office of the Provincial Secretary, le 10 mars 1951.this 10th day of March, 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 29655 JEAN BRUCHÉSI.29655-o Under-Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'hono- Notice is hereby given that the Honourable rable Secrétaire de la province a dûment reçu the Provincial Secretary has duly received the le troisième original de la déclaration de fondai third copy of the original of the declaration of tion du syndicat coopératif \"Le Syndicat Coopé- foundation of the cooperative syndicate \"Le ratif des Chemins d'Hiver du Rang Dix, de Nor- Syndicat Coopératif des Chemins d'Hiver du mandin\", en date du 27 janvier 1951, dont le Rang Dix, de Normandin\", under date the 27th siège social est situé à Normandin, comté de day of January, 1951, whereof the head office is Roberval, et que ce document a été déposé dans at Normandin, county of Roberval, and that les archives du Secrétariat de la province.the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Donné au bureau du Secrétaire de la province Given at the office of the Provincial Secretary, le 13 février 1951.this thirteenth of February, 1951.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHÉSI, 29657-o JEAN BRUCHÉSI.29657 Under Secretary of the Province.L.N.Messier Limitée L.N.Messier Limitée Règlement concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à cinq.\"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de cinq directeurs dont trois formeront quorum.\" Certifié conforme, ce 9 février 1951.Le Secrétaire, 29658-o J.L.ROUSSEAU.By-law respecting the increase of the number of Directors from three to five.\"The affairs of the company will be managed by a Board of five Directors, three of whom will form the quorum.\" Certified True Copy, February 9,1951.J.L.ROUSSEAU, 29658 Secretary.Avis est donné que, sur la recommandation Notice is hereby given that upon the recom- de l'Assistant-procureur général, l'honorable mendation of the Deputy Attorney General, Secrétaire de la province a approuvé, le 6 mars the general by-laws of the \"Corporation de 1951, les règlements généraux de la \"Corpora- l'École d'Agriculture de Ste-Croix\", as adopted tion de l'Ecole d'Agriculture de Ste-Croix\", at the meeting held on the 31st of January, tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 31 janvier 1951, were approved by the Honourable the 1951, et ce, conformément aux dispositions de Provincial Secretary on the 6th day of March, l'article 225 de la Loi des compagnies de Que- 1951, pursuant to the provisions of section bec (S.R.Q.1941, chapitre 276).225 of the Quebec Companies' Act (R.S.Q., 1941, chapter 276).Donné au bureau du Secrétaire de la province t Given at the office of the Provincial Secretary, le 9 mars 1951.this ninth day of March, 1951.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHÉSI, 29673-o JEAN BRUCHÉSI.29673 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné par le maire Notice is hereby given by the mayor and et le secrétaire-trésorier de la municipalité de secretary-treasurer of the municipality of the la paroisse Notre Dame de Bonsecours, comté parish of Notre-Dame de Bonsecours, county of de Papineau, que le Lieutenant-gouverneur en Papineau, that the Lieutenant-Governor in conseil a approuvé, en date du 1er février 1951, Council, has approved, under date of February suivant un rapport du Comité de l'honorable 1st, 1951, following a report from the Com- Gonseil exécutif, le changement du nom de la mittee of the Honourable the Executive Council municipalité de la paroise de N.-D.Bonsecours he change of name of the municipality of the, en celui de municipalité de Fassett, comté de parish of N.-D.Bonsecours, to that of Muni- Papineau.cipality of Fessett, county of Papineau.Conformément aux dispositions de l'article Pursuant to the provisions of article 48 of de l'article 48 du Code municipal, ce change- the Municipal Code, such change of name will gement de nom entre en vigueur à compter de come into force from and after the date of the la date de la publication du présent avis dans la publication of the present notice in the Quebec Gazette officielle de Québec.Official Gazette.Fassett, Que., le 20 février 1951.Fassett, Que., February 20,1951.' Le Maire, C.GENDRON, .C.GENDRON.Mayor.Le Secrétaire-trésorier, YVON RACICOT, 29674-o YVON RACICOT.29674 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1961, Vol.83, No.11 931 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Coopérative d'Habitation de St-Patrice de Tingwick\", en date du cinq février 1951, dont le siège social est à Tingwick, comté d'Arthabaska,' et que ce document a été déposé 'dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 1er mars 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29675-0 JEAN BRUCHÉSI.Chambre du Conseil législatif Québec, 7 mars 1951.Aujourd'hui, à trois heures de l'après-midi, l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur s'est rendu à la Chambre du Conseil législatif au Palais législatif.Les membres du Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur d'y faire requérir la présence de l'Assemblée législative et, cette Chambre s'y étant rendue, le greffier de la couronne en chancellerie a lu les titres des bills à être sanctionnés comme suit: 22 Loi concernant la régie des loyers.24 Lci modifiant la Loi des tribunaux judiciaires.26 Loi pour améliorer les pensions des vieillards et des aveugles.30 Loi modifiant la Loi du crédit agricole du Québec.40 Loi concernant la municipalisation de l'énergie électiique par la ville de Mégantic.42 Loi modifiant la Loi pour organiser la coloni- sation selon des méthodes progressives et rationnelles.43 Loi modifiant la Loi des abeilles.45 Loi concernant l'enregistrement des obliga- tions des corporations municipales et scolaires.46 Loi relative aux coopératives d'électricité.47 Loi concernant la sécurité publique et la Loi des véhicules automobiles.49 Loi modifiant la Loi de l'instruction publi- que.50 Loi érigeant la municipalité du canton Boyer, dans le comté de Labelle.51 Loi relative à la réouverture des usines de la région de Chicoutimi.52 Loi concernant la durée des conventions col- lectives.53 Loi concernant le renouvellement des titres de certains droits de mines et concessions minières.55 Loi concernant la Commission de relations ouvrières de la province de Québec.57 Loi modifiant la Loi médicale de Québec.101 Loi modifiant la charte de la ville de Matane.102 Loi concernant la succession de feu l'hono- rable Joseph Masson.103 Loi concernant la corporation de la ville de Bromptotiville et les commissaires d'écoles du même lieu.104 Loi concernant lafsuccession d'Armand Gau- thier.105 Loi concernant la succession d'Hermann Gottlieb Huber.106 Loi concernant les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Victoria ville.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Coopérative d'Habitation de St-Patrice de Tingwick\", under date the fifth day of February, 1951, whereof the head office is at Tingwick, county of Arthabaska, and that the said document has been iiled in the archives of the.department of the Provincial Secretary.'Given at the office of the Provincial Secretary this first day of March, 1951.JEAN BRUCHÉSI, .29675 Under Secretary of the Province.Legislative Council Chamber Quebec, 7 th of March, 1951.This day, at three o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor proceeded to the Legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and, that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 22 An Act respecting the regulation of rentals.24 An Act to amend the Courts of Justice Act.26 An Act to improve pensions for the aged and the blind.30 An Act to amend the Quebec Farm Credig Act.40 An Act respecting the municipalization of electric power by the town of Megantic.42 An Act to amend the Act to Organize Coloni- sation according to Progressive and Rational Methods.43 An Act to amend the Bees Act.45 An Act respecting the registration of de- bentures of municipal and school corporations.46 An Act respecting electricity cooperatives.47 An Act respecting public safety and the Motor Vehicles Act.49 An Act to amend the Education Act.i 50 An Act to erect the municipality of the town- ship of Boyer, in the county of Labelle.51 An Act respecting the reopening of the mills of the Chicoutimi Region.52 An Act respecting the duration of collective agreements.53 An Act respecting the renewal of the titles of certain mining lights and mining concessions.55 An Act respecting the Labour Relations Board of the Province of Quebec.57 An Act to amend the Quebec Medical Act.101 An Act to amend the chaiter of the town of- Matane.102 An Act respecting the estate of the Honoura- ble Joseph Masson.103 An Act respecting the Corporation of the town of Bromp ton ville and the School commissioners for the same locality.104 An Act respecting the estate of Armand Gau- thier.105 An Act respecting the estate of the late Hermann Gottlieb Huber.106 An Act respecting the School Commissioners for the municipality of the town of Victo-riaville. 932 GAZETTE OFFICIELLE DE QLÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 83, N°'11 108 Loi modifiant la charte de la ville de Louise- ville.109 Loi modifiant la charte de la cité d'Outre- mont.110 Loi changeant le nom de Léopold-Maicel Lortie en celui de Léopold-Marcel Villeneuve.111 Loi concernant les Commissaires d'écoles pour la municipalité de 4a cité de Saint-Jérôme, dans le comté de Terrebonne.112 Loi concernant l'instruction publique dans la cité de Granby.113 Loi relative à la ville de Coaticook.114 Loi modifiant la charte de la ville de La Tuque.116 Loi autorisant le Recteur, et les marguilliers de St.Matthew's Church de la cite de Québec, à vendre le lot numéro 3,296 au cadastre du quartier Saint-Jean de la cité et du district de Québec.117 Loi concernant l'admission de Me André Poirier à l'étude et à l'exercice de la profession de notaire., 118 Loi concernant l'adoption de Henri-Maurice Morin.119 Loi concernant la succession de l'honorable Paul-G.Martineau.120 Loi autorisant la Chambre des notaires de la province de Québec à admettre Raphaël, Esposito.122 Loi modifiant la charte de la Commission Métropolitaine de Montréal concernant la création d'un fonds de pension pour ses fonctionnaires et employés permanents.123 Loi autorisant le Collège des chirurgiens den- tistes de la province de Québec, à admettre Jean-Théodore Chenevert.125 Loi concernant l'imposition d'une taxe de ventes et d'une taxe d'écutation pour fins municipales et scolaires dans la ville de Mégantic.126 Loi autorisant les Commissaires d'écoles de la cité de Thetford-Mines à imposer une taxe d'éducation.127 Loi concernant l'adoption de Margaret Anne Redmcnd et le changement de son nom de famille en celui de Berry.128 Loi modifiant la charte de la ville de Laval Ouest.129 Loi modifiant la charte de la ville de Sainte- Rose.130 Loi modifiant la charte de la ville LaSalle.131 Loi modifiant la Loi constituant en corpora- tion l'Institut des Soeurs de l'enfance de Jésus et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne.133 Loi modifiant la charte de la ville de Rich- mond.134 Loi annulant une clause du contrat de dona- tion de Eugène Girard à Anna Girard.135 Loi autorisant les Commissaires d'écoles de Plessisville à lever une taxe d'éducation.136 Loi modifiant la charte de la ville de Black Lake.137 Loi concernant la cité de Grand'Mère et les commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Mère dans le comté de Cham-plain et pourvoyant à une évaluation fixe des biens industriels imposables de certaines compagnies.138 Loi concernant les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf.140 Loi portant ratification du règlement numéro 217 et du contrat de la municipalité du 108 An Act to amend the charter of the city of Louise ville.109 An Act to amend the charter of the city of Outremont.110 An Act tc change the name of Leopold Mar- cel Lortie to Leopold Marcel Villeneuve.111 An Act respecting the School Commissioners for the municipality of the city of St.Jérôme, in the county of Terrebonne.112 An Act respecting education in the City of Granby.113 An Act respecting the town of Coaticook.114 An Act to amend the charter of the town of La Tuque.116 An Act to empower the Rector and Church Wardens of St.Matthew's Church, of the city of Quebec, to sell lot number 3,296 of the cadastral plan of St.John's ward, of the city and district of Quebec.117 An Act respecting the admission of- Me André Poirier to the study and practice of the notarial profession.118 An Act respecting the adoption of Henri Maurice Morin.119 An Act respecting the estate of the Honour- able Paul.G.Martineau.120 An Act to authorize the Board of Notaries of the Province of Quebec to admit Raphaël Esposito.122 An Act to amend the charter of the Montreal Metropolitan Commission respecting the creation of a pension fund for its permanent officers and employees.123 An Act to authorize the College of Dental Surgeons of the Province of Quebec to admit Jean Théodore Chenevert.125 An Act respecting the levying of a sale tax and of an education tax for municipal and school purposes in the town of Me-gantic.126 An Act to authorize the School Commission- ers of the city of Thetford Mines to impose an education tax.127 An Act respecting the adoption of Margaret Anne Redmond and the change of her surname to Berry.128 An Act to amend the charter of the town of Laval West.129 An Act to amend the charter of the town of Ste.Rose.130 An Act to amend the charter of the town of LaSalle.131 An Act to amend the Act to incorporate L'Institut des Sœurs de l'enfance de Jésus et de Marie dites de Sainte-Chrétienne.133 An Act to amend the charter of the town of Richmond.134 An Act to annul a clause of the deed of gift from Eugène Girard to Anna Girard.135 An Act to authorize The school commis-, sioners of Plessisville to impose an education tax.136 An Act to amend the charter of the town of Black Lake.137 An Act respecting the city^jf Grand'Mère and the School commissioners for the municipality of Grand'Mère in the county of Champlain and providing for a fixed valuation of the tenable industrial property of certain companies.138 An Act respecting The school commissioners for the municipality of the village of St.Raymond, in the county of Portneuf.140 An Act to ratify by-law number 217 and a contract of the Municipality of the village QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 933 village de Montebello, et d'une résolution de la commission scolaire de Montebello.141 Loi modifiant la charte de la cité de Chicou- timi.142 Loi concernant les commissaires d'écoles pour la municipalité de Shawinigan-Falls, dans le comté de Saint-Maurice.143 Loi modifiant la charte de la cité de Drum- mond ville.144 Loi érigeant la municipalité du village de Chute-aux-Outardes et la municipalité de Ragueneau pour fins municipales seulement.148 Loi concernant la Société coopérative agri- cole du canton de Granby.149 Loi modifiant la charte de la cité de Shawi- nigan Falls.150 Loi modifiant la charte de la cité de Magog.151 Loi modifiant la charte de la Ville Saint- Laurent.153 Loi modifiant la charte de la ville de Victo- ria ville.154 Loi modifiant la charte de la cité de Sillery.155 Loi modifiant la charte de la cité de Saint- Jérôme.156 Loi modifiant la Loi constituant en corpora- tion \"Les Sœurs Adoratrices du Piécieux-Sang de Mont-Laurier\" et changeant leur nom en celui de Les Moniales Bénédictines du Précieux-Sang de Mont Laurier.157 Loi concernant le testament de Real Lamon- tagne.159 Loi modifiant la charte de la cité des Trois-Rivières.161 Loi concernant une donation faite par Louis- A.Gosselin et dame Aldéa Bélanger, son épouse, en faveur de Gérard Gosselin et Marcel Gosselin.162 Loi concernant la'succession Joseph-B.Le- febvre.167 Loi modifiant la charte du collège de Lévis.168 Loi modifiant la loi 15 George V, chapitre 45, concernant les écoles protestantes dans la cité de Montréal et ses environs.169 Loi modifiant la loi 32 Victoria, chapitre 16, concernant l'éducation dans la province.170 Loi modifiant la loi 21 George V, chapitre 63, concernant l'éducation de certains enfants.171 Loi concernant les propriétés de la Fédéra- tion diocésaine de Montréal de la Jeunesse étudiante catholique du Canada Incorporée, de la Fédération diocésaine de Montréal de la Jeunesse Indépendante catholique féminine Incorporée et de la Jeunesse étudiante catholique Incorporée.172 Loi concernant l'évaluation des immeubles de la Mobbs & Lewis (Canada) Ltd.par la municipalité et les commissaires d'éco-.les de Notre-Dame-du-Lac.174 Loi modifiant la Loi concernant la commission des écoles catholiques des Trois-Rivières.175 Loi autorisant la Corporation des opticiens d'ordonnances de la province de Québec à admettre Paul-Henri Maranda et Paul-Êmile Tardif.176 Loi prorogeant l'administration municipale du village minier de Pascalis.178 Loi ratifiant une résolution de la Corporation du village de Crabtree et une résolution des commiassaires d'écoles pour la of Montebello, and a resolution of the School commisison of Montebello.141 An Act to amend the charter of the city of Chicoutimi.142 An Act respecting The school commissioners for the municipality of Shawinigan Falls, in the county of St.Maurice.143 An Act to amend the charter of the city of Drummondville.144 An Act to erect the muni ipality of the village of Chute aux Outardes and the muni, ipality of Ragueneau for municipal purposes only.148 An Act respecting the Cooperative Agri- cultural Association of the township of Granby.149 An Act to amend the charter cf the city of Shawinigan Falls.150 An Act to amend the charter of the city of Magog.151 An Act to amend the charter of the town of St.Laurent.153 An Act to amend the charter of the town of Victoriaville.154 An Act to amend the charter of the city of Sillery.155 An Act to amend the charter of the city of St.Jérôme.156 An Act to amend the act to incorporate Les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de Mont-Laurier and to change their name to that of Les Moniales Bénédicines du Précieux Sang de Mont-Laurier.157 An Act respecting the will cf Real Lamon- tagne.159 An Act to amend the charter of the city of Trois-Rivières.161 An Act respecting a gift made by Louis A.Gosselin and Dame Aldéa Bélanger, his wife, in favour of Gérard Gosselin and Marcel Gosselin.162 An Act respecting the estate of Joseph B.Lefebvre.167 An Act to amend the charter of the College of Levis.168 An Act to amend the Act 15 George V, chap- ter 45 respecting Protestant Schools in and around the city of Montreal.169 An Act to amend the Act 32 Victoria, chapter 16, respecting education in this province.170 An Act to amend the Act 21 George V, chapter 63, respecting the education of certain children.171 An Act respecting the property of la Fédéra- tion diocésaine de Montréal de la Jeunesse étudiante catholique du Canada Incorporée, of la Fédération diocésaine de Montréal de la Jeunesse Indépendante catholique féminine Incorporée and of la Jeunesse étudiante catholique Incorporée.172 An Act respecting the valuation of the im- moveable of Mobbs and Lewis (Canada) Limited, by the municipality cf the school commissioners of Notre-Dame-du-Lac.174 An Act to amend the Act respecting the Three Rivers Catholic School Commission.175 An Act to authorize the Corporation of Dis- pensing Opticians of the Province of Quebec to admit Paul-Henri Maranda and Paul-Émile Tardif.176 An Act to extend the municipal administra- tion of the mining village of Pascalis.178 An Act to ratify a resolution of the Corporation cf the village of Crabtree and a resolution of the school commissioners for the 934 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 83, N° 11 paroisse du Sacré-Cœur-de-Jésus de Crab-tree Mills (Joliette).179 Loi modifiant la charte de la Compagnie de Jésus.184 Loi concernant la corporation du village de Sainte-Anne-de-Beaupré et les commissaires d'écoles pour la municipalité scolaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans le comté de Montmorency.186 Loi interprétant le testament de Nora Jennie Welch.187 Loi autorisant le Collège des chirurgiens- dentistes de la province de Québec à admettre le docteur Frederick Reichman à l'exercice de la chirurgie dentaire dans la province de Québec.188 Loi changeant le nom de Francis Joseph Starzynski en celui de Francis Joseph Starr.190 Loi modifiant la charte de la ville de Belœil.225 Loi modifiant la Loi des maîtres électriciens de la province de Québec.226 Loi concernant les municipalités scolaires catholique et protestante de la cité de Ncranda.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 68 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1951, et pour d'autres fins.A ce bill la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: \"Au nom de Sa Majesté, Son Honneur le Lieutenant-gouverneur remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence et sanctionne ce bill.\" 29683-o ' - Alumnae Society of McGill University Extrait des nouveaux règlements de la société \" nommée ci-dessus tels que décrétés le 27 novembre 1950, concernant une diminution \"du nombre dtrses directeurs de quatorze à dix: \"Règlement N° 6\u2014Bureau de Direction\u2014 1° Nombre, qualification et élection.Les affaires de la société seront administrées par un bureau de direction de dix directeurs.\".Ceitifié vraie copie.Le Président, HELEN R.SAVAGE, Le Secrétaire honoraires, 29686 MERLE G.PEDEN.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fonda-% tion du syndicat coopératif \"Syndicat Industriel de St-Frédéric\", en date du 5 mars 1951, dont le siège social est à Saint-Frédéric de Beauce, comté de Beauce, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 7 mars 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29687-o JEAN BRUCHÉSI.parish of Sacré-Cœur-de-Jésus de Crab-tree (Joliette).179 An Act to amend the charter of the Society of Jesus.184 An Act respecting the Corporation of the village of Ste.Anne de Beaupré, and the school commissioners for the school municipality of Ste.Anne de Beaupré, in the county of Montmorency.186 An Act to interpret the will cf Nora Jennie Welch.187 An Act to authorize tho College of Dental Surgeons of the Province of Quebec to admit Doctor Frederick Reichman to the practice of dental surgery in the Province of Quebec.188 An Act to change the name of Francis Joseph Starzynski to that of Francis Joseph Starr.190 An Act to amend the charter of the town of Belœil.* 225 An Act to amend the Master Electricians of the Province of Quebec Act.226 An Act respecting the Catholic and Pro- testant school municipalities of the city of Noranda.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council, in the following words: \"In His Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 68 An Act granting to His Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March, 1951, and for other purposes.To this bill the Royal assent was signified in the following words: \"In His Majesty's name, His Honour the Lieutenant-Gove-nor thanks His loyal subjects, accepts their benevolence and assents to this bill.\" 29683-o - Alumnae Society of McGill University Extract from the new by-laws of the above named society, as enacted on November 27th 1950, concerning a decrease in the directorate thereof from fourteen to ten.\"By-law No.6\u2014Board of Directors.1.Number, qualification and election.The affairs of the Society shall be managed by a Board of ten directors.\".Certified true copy.HELEN R.SAVAGE, President.MERLE G.PEDEN.29686-o Honorary Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Industriel de St-Frédéric\", under the date the 5th day of March, 1951, whereof the head office is at Saint-Frédéric de Beauce, county of Beauce, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this seventh day of March, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29687 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.88, No.11 935 AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association Indépendante des Employés de Caverhill, Learmont & Co.Limited\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 14 mars 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est-situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la Province, 29692-0 JEAN BRUCHÉSI.DISCOURS DU TRÔNE Prorogation Honorables messieurs du Conseil législatif, Messieurs de l'Assemblée législative.Aujourd'hui se termine la troisième session de la vingt-troisième législature.Remarquable par lés lois fructueuses que vous avez adoptées, cette session témoigne, une fois de plus, du désir sincère de mon gouvernement que notre législation soit parfaitement adaptée à nos saines traditions religieuses et nationales et corresponde au progrès et à la prospétité durables de notre province.Messieurs de VAssemblée législative, Au nom de Sa Majesté, je vous remercie d'avoir voté les subsides nécessaires à l'administration de la province.Honorables messieurs du Conesil législatif, Messieurs de l'Assemblée législative, En prorogeant la législature, je demande au Bon Dieu de bénir notre chère province et d'accorder au monde une paix juste et durable, fondée sur les préceptes évangéliques.29696-o The Montreal Clinical Society Extrait des règlements de la société nommée ci-dessus, tels qu'approuvés à l'assemblée générale spéciale tenue le 24 janvier 1951, concernant une diminution du nombre des directeurs de huit à cinq (8 à 5): \"Article V \u2014 Directeurs et officiers \u2014 Article 1: a) Les affaires de la société seront administrées par un bureau de direction de cinq (5) directeurs.\" Certifié extrait conforme, Montréal, 6 février 1951.Le Secrétaire, 29698 C.SCHNEIDERMAN.Chambre du Conseil législatif Québec, 14 mars 1951.Aujourd'hui, à quatre heures et trente de l'après-midi, l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur s'est rendu à la Chambre du Conseil législatif au Palais législatif.Les membres du Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur d'y faire requérir la présence de l'Assemblée législative et, cette Chambre s'y NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association Indépendante des Employés de Caverhill, Learmont & Co.Limited\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on March 14th, 1951.The principal place of business of the said professional' syndicate is at Montreal, judicial district of Montreal.\u2022 JEAN BRUCHÉSI, 29692 Under Secretary of the Province.SPEECH FROM THE THRONE Prorogation Honourable Gentlemen of the Législative Council, Gentlemen of the Legislative Assembly, The third session of the Twenty-Third Legislature is closing today.This session, which was particularly noteworthy for the constructive laws which you adopted, is a further proof of the sincere desire of my Government that our legislation be perfectly adapted to our sound religious and national traditions, and that it should promote the progress and the enduring prosperity of Our Province.Gentlemen of the Legislative Assembly, In the name of His Majesty, I thank you for having vtoed the moneys needed for the administration of the Province.Honourable Gentlemen of the Legislative Council, Gentlemen of the Legislative Assembly, In proroguing this session of our Legislature I Pray Almighty God to bestow His blessings on our dear Province, and to confer upon the world a just and lasting peace founded on the principles of the Gospel.29696-o The Montreal Ctjinical Society Extract of the by-laws of the above named society, as approved' at the special general meeting held on January 24th, 19.51, concerning a reduction in the number of directors from eight to five (8 to 5): \"Article V \u2014 Directors and Officers \u2014 Sec.1 : o) The affairs of the Society shall be managed by a Board of five (5) Directors.\" Certified true extract, Montreal, Feburary 6th, 1951.C.SCHNEIDERMAN, ' 29698-o Secretary.Legislative Council Chamber Quebec, 14th of March, 1951.This day, at foui and a half o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor proceeded to the Legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and, that House being 936 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 88, N° 11 étant rendue, le greffier de la couronne en chan-\u2022 cellerie a lu les tirres des bills a être sanctionnés comme suit : B Loi modifiant la Loi du barreau; 58 Loi concernant l'instruction des causes dans le district judiciaire de Montréal; 59 Loi modifiant le Code civil; 60 Loi concernant la Commission de transport de Montréal et le capital-actions de la Compagnie des tramways de Montréal; 61 Loi concernant la perception de certaines taxes spéciales; 63 Loi érigeant la ville des Sept-Iles, dans le comté de Saguenay; 64 Loi concernant l'École provinciale de mé- decine vétérinaire; 67 Loi concernant la ville d'East-Angus; 69 Loi modifiant la Loi des écoles de protection de la jeunesse;.70 Loi concernant la construction d'un marché central des produits agricoles dans la région métropolitaine de Montréal; 71 Loi concernant la tragédie du mont Obiou; 72 Loi modifiant la loi 14 George VI, chapitr** 48, concernant les cantons de Sagard et de Saguenay; 73 Loi concernant la protection civile dans la province; 74 Loi concernant le détournement d'une partie des eaux de la rivière Mégiscane; 75 Loi concernant le sanatorium Ross; 100 Loi modifiant la charte de la cité de Montréal; 107 Loi modifiant la charte de la cité de Québec; 115 Loi modifiant la charte de la cité de Sherbrooke; 121 Loi modifiant la Loi concernant l'instruction publique dans la cité de Sherbrooke; 146 Loi conférant certains pouvoirs à la corporation municipale de la paroisse de Saint-Laurent; 160 Loi modifiant la charte de la cité^de Lon-gueuil; 177 Loi refondant la charte de la ville de Beau-port; 180 Loi modifiant la charte de la ville de Mont-Joli; 183 Loi constituant en corporation l'Hôpital Laval; 185 Loi validant certaines-résolutions et certains contrats passés par la corporation de l'Ascension-de-Notre-Seigneur et par les commissaires d'écoles pour la, municipalité de Gamier,, dans le comté de Lac-Saint-Jean; 189 Loi concernant la succession de Joseph Drapeau; 192 Loi concernant la Commission de transport de Montréal; 193 Loi validant le titre de Canadian Tube & Steel Products, Limited, à certaines propriétés; 194 Loi concernant l'éducation à Arvida; 228 Loi concernant la Société coopérative fédérée des agriculteurs de là province de Québec.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 54 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1951, et pour d'autres fins.present the Clerk of the Crown in Chancery read the tiles of the bills to be sanctioned as follows: B An Act to amend the Bar Act; 58 An Act respecting the trail of coses in the judicial district of Montreal; 59 An Act to amend the Civil Code; 60 An Act respecting the Montreal Transpor- tation Commission and the capital stock of the Montreal Tramways Company;, 61 An Act respecting the collection of certain.special taxes; 63 An Act to erect the town of Sept lies, in in the county of Saguenay; 64 An Act respecting the Provincial School of Veterinary Médecine; 67 An Act respecting the town of East Angus; 69 An Act to amend the Ycuth Protection Schools Act ; 70 An Act respecting the construction of a central market for agricultural products in the Metropolitan region of Montreal; 71 An Act respecting the mount Obiou tragedy; 72 An Act to amend the act 14 George VI, chapter 48, respecting the townships of Sagard and Saguenay; 73 An Act respecting the civil protection in the province; 74 An Act respecting the diversion of part of the waters of the Mégiscane River; 75 An Act respecting the Ross Sanatorium; 100 An Act to amend the charter of the city of Montreal; 107 An Act to amend the charter of the city of Quebec; 115 An Act to amend the charter of the city of Sherbrooke; 121 An Act to amend the Act respecting education in the city of Sherbrooke; 146 An Act to grant certain powers to the municipal corporation of the parish of Saint-Laurent; 160 An Act to amend the charter of the city of Longueuil; 177 An Act to consolidate the harter of the town of Beauport; 180 An Act to amend the charter of the town of Mont-Joli; 183 An Act to incorporate L'Hôpital Laval; 185 An Act to validate certain resolutions and contracts passed by La corporation de l'Ascension-de-Notre-Seigneur and by the school commissioners for the municipality of Gamier, in the county of Lake St.John; 189 A Anct respecting the estate of Joseph Drapeau; 192 An Act respecting the Montreal Transporta- tion Commission; 193 An Act to validate the title of Canadian Tube & Steel Products, Limited, to certain properties; 194 An Act respecting education in Arvida; 228 An Act iespecting the Société co-operative fédérée des agriculteurs de la province de Québec.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council, in the following words: \"In His Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 54 An Act granting to His Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March, 1952, and for other purposes. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 937 A ce bill la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: \"Au nom de Sa Majesté, Son Honneur le lieutenant-gouverneur remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence et sanctionne ce bill.\" 29697-o Assemblée The Canada & Gulf Terminal Railway Company Avis est donné qu'une assemblée générale et spéciale des actionnaires de la compagnie ci-dessus, sera tenue à Rimouski, 1 rue St-Jean, à 11 heures A.M.(heure avancée) le 28 mars 1951, pour les fins ordinaires d'une assemblée générale annuelle.Le Secrétaire, 29678-1 l-2-o P.-E.GAGNON.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la robe dans la province de Québec.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la robe dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 3519 du 24 septembre 1940, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret, dans sa teneur modifiée; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 3519, soit modifié comme suit: 1.L'article IX est remplacé par le suivant : \"IX.Les employeurs sont assujettis aux clauses d'un contrat de travail intervenu entre eux et leurs salariés, soit verbalement ou par écrit, avant ou après l'entrée en vigueur de ce décret, lorsque tel contrat stipule des salaires plus élevés, soit à l'heure, à la semaine ou autrement, ou des taux à la pièce plus élevés que ceux fixés dans le présent décret et plus spécialement dans les articles VULl, X et XII.Les employeurs ainsi assujettis ne peuvent réduire ces taux plus élevés et To this bill the Royal assent was signified in the following words :.\"In^His Majesty's name, His Honour the Lieutenant-Governor thanks His loyal subjects, accepts their benevolence and assents to this bill.\" 29697-o Meeting The Canada & Gulf Terminal Railway Company Notice is hereby given that a general and special meeting of the shareholders cf the above Company will be held at Rimouski, 1 St-John Street, at 11 o'clock (daylight saving time) the 28th day of March 1951, for the usual purposes of a general annual meeting.P.-E.GAGNON,^-29678-1 l-2-o Secretary.Orders in Concil ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 230 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Pari \"A\" Concerning amendments to the decree relating to the dress industry in the Province of Quebec.Whereas pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the dress industry in the province of Quebec, rendered obligatory by the decree number 3519 of September 24, 1940, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree, as amended; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27, 1951; Whereas the objections set forth have been considered in pursuance of the provisions of the Act; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number.3519, be amended as follows: 1.Section IX is replaced by the following: \"IX.Employers are bound by those clauses of a lease and hire of work entered into by them with their employees either verbally or in writing before or after the coming into force of this Decree, which provide for higher wages per hour, per week, or on any other basis, or higher piece work rates than those fixed in the present Decree and especially by Sections VIII, X and XH thereof.- Employers so bound are prohibited from reducing and must maintain such higher 938 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1961, Tome 83, N° 11 doivent les maintenir pour tous les salariés avec lesquels de tels contrats ont été faits.\" 2.L'article IX-A suivant est ajouté: \"IX-A.Indemnité de vie chère: a) A l'excep-ception des travailleurs à domicile et des apprentis gagnant moins de cinquante cents ($0.50) l'heure, chaque salarié assujetti aux dispositions de ce décret, qu'il travaille sur une base de temps ou à la pièce, doit recevoir un boni de vie chère de sept cents et demi ($0.7^) l'heure en plus de son taux régulier de salaire.b) Les travailleurs à domicile doivent recevoir comme boni de vie chère une somme additionnelle égale à quinze pour cent (15%) des salaires qu'ils gagnent en vertu des dispositions de l'article XII du présent décret.c) Les apprentis gagnant moins de cinquante cents ($0.50) l'heure doivent recevoir un boni de vie chère de cinq cents ($0.05) l'heure en plus de leur salaire et des augmentations prévues à l'article X du présent décret.d) Chaque employeur doit présenter un rapport à la Commission conjointe de l'industrie de la robe de la province de Québec indiquant séparément le paiement des bonis de vie chère ci-haut mentionnés à chaque salarié assujetti au présent décret, et ce, pour la période de paye, de la manière et dans le délai prescrits par la Commission conjointe, et sur les formules que pourra fournir ladite Commission.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 29693-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL .CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"B\" Comcernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans les comtés de Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Charlevoix, Chicoutimi, Lac St-Jean, Roberval, Rouyn-Norandà et Saguenay.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation de certaines modifications au décret numéro 1743 du 11 juillet 1941 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans les comtés de Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Charlevoix, Chicoutimi, Lac Saint-Jean, Roberval, Rouyn-Noranda et Saguenay; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travad: Que ledit décret, numéro 1743, soit modifié comme suit: Le paragraphe \"a\" de l'article V est remplacé par.le suivant: \"a) Les taux minima de salaires suivants doivent être payés pour chacun des métiers ci-dessous décrits, dans les limites de la juridiction wages and rates, with respect to those employees with whom such agreements were made.\" 2.The following section IX-A is added: \"IX-A.Cost of living bonus: a) Except for homeworkers and those apprentices earning less than fifty cents ($0.50) per hour, each and every employee governed by the provisions of this Decree whether the works on a time work or a piecework basis, shall receive a cost of living bonus of seven and one half cents (7J^c) per hour in addition to and over and above his prevailing wages.b) Homerworkers shall receive as a cost of living bonus an additional sum amounting to fifteen per cent (15%) of the wages they earn under the provisions of Section XH of the present Decree.c) Apprentices earning less than fifty cents ($0.50) per hour shall receive a cost of living bonus of five cents (5c) per hour in addition to and over and above their wages and any escalator increases as provided by Section X hereinafter.d) Each and every employer must file a report to the Joint Committee for the Dress Industry of the Province of Quebec showing separately the payments of the aforementionned cost of living bonuses made to each and every employee governed by the present Decree within the delay, for the pay period, in the manner and on such forms as may be prescribed and furnished by the said Joint Commission.\" (Document \"A\" annexed to the Order) A.MORISSET, 29693-o Clerk of the Executive Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 230 .Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Fart \"B\" Concerning amendments to the decree relating to the construction industry in the counties of Abitibi-East, Abitibi-West, Charlevoix, Chicoutimi, Lake St.John, Roberval, Rouyn-Noranda and Saguenay.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of amendments to the decree number 1743 of July 11, 1941, and amendments, relating to the construction industry in the counties of Abitibi-East, Abitibi-West, Charlevoix, Chicoutimi, Lake St.John, Roberval, Rouyn-Noranda and Saguenay; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27, 1951; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1743, be amended as follows: Subsection \"a\" of section V is replaced by the following: \"a) The following minimum wage rates shall be paid for each one of the trades hereunder mentioned within the limits of the territorial QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 939 territoriale du présent décret.Cependant, dans les zones I, II et III, ces taux doivent être modifiée d'accord avec les fluctuations de l'indice fédéral du coût de la vie, de la manière suivante, en prenant comme base de calcul 170 points: A chaque dix (10) points d'augmentation ou de diminution du coût de la vie, selon ledit indice, les taux horaires minima payables seront de $0.05 supérieurs ou inférieurs suivant'le cas: Taux minima en vigueur à compter du 1er janvier 1951 dans la zone I-A et à compter du 15 novembre 1950 dans les zones I, II et III.jurisdiction of the present decree.However, in zones I, II and HI, these rates shall be amended in pursuance of the fluctuations of the Federal cost of living index as follows, taking 170 points as a calculation basis : For each ten point increase or decrease in the cost of living, as per the index, the hourly minimum rates payable shall be $0.05 highei or lower, as the case may be: Minimum rates in force as from January 1, 1951, for zone I-A and from November 15, 1950, for zones I, II and III.Metiers \u2014 Trades: Zones i i-A ii in Aide \u2014Helper.$0.95 $0.90 $0.85 $0.75 Briqueteur \u2014 Bricklayer.125 120 115 105 Charpentier-menuisier \u2014 Cai pente r-joiner.1.15 1.10 1.05 0.95 Chauffeur de bouilloires à vapeur \u2014 Fireman, steam boiler.1.00 0.95 0.90 0.80 Chauffeur de camion \u2014Truck driver.0,95 0.90 0.85 0.75 Chauffeur de pelle à vapeur \u2014 Steam shovel fireman.1.05- 1.00 0.95 0.85 Conducteur, attelage simple ou double \u2014 Horse driver, one or two horses.0.95 0.90 0.85 0.75 Couvreur (ardoise, tuile, composition, amiante) \u2014r Roofer (slate, tile, asbestos, composition).1.05 1.00 0.95 0.85 Electric icn \u2014 Electrician.1 10 1 05 1 00 0 9° Électritien (hemme de ligne) \u2014 Electrician (line man).1.05 1.00 0.95 0.85 Faiseur de planchers \u2014 Floor layer.1.10 1.05 1.00 0.90 Finisseur de ) Les frais de déplacement des salariés envoyés en-dehors de la cité de Saint-Jean et de la ville d'Iberville sont à la charge de l'employeur sans pour cela que leur salaire soit réduit.De plus le repas du midi est à la charge de l'employeur si l'employé n'a pas été averti la veille.Plumber, steamfitter, pipe mechanic: Journeyman.1.20 Junior journeyman.1.10 Pipe welder (acetylene or electric).1.20 Employee committed to the installation o of oil burners.1.20 Sprinkler fitter.1.20 Pipe insulation worker.1.20 Sheet-metal worker and tinsmith-roofer (shop or field).1.20 Roofer \u2014 slate, tile.1.45 Roofer \u2014 Composition, gravel, sand, asphalt.1.10 Boilerman.0.85 Labourer, hod carrier.0.85 Labourer (common worker).0.85 Rigger.1.10 Compressor operator.1.05 Truck driver.0.90 Carter.0.85 Steam mixer operator.or large gasoline mixer operator.1.20 Electric mixer operator or small gasoline .mixer operator.0T85 Reinforcing steel erector.1.20 Cork insulation layer.1.25 Mastic floor finisher.1.15 Mastic floor layer.1.35 Kettleman (flooring only).1.05 Asphalt, tile layer.1.00 Fireman (construction).0.85 Terrazzo layer.1.43 Terrazzo polishing machine operator: Dry polishing.1.28 Water polishing.\u2022 1.10 Marble layer.1.50 Tile layer.1.43 Stationary or portable engineman.1.05 Freight elevator operator.0.90 Drill and powder man.1.10 Machinist.1.10 Blacksmith on job.1.10 Crane operator.1.20 Shovel operator.1.20 Tractor operator.1.00 Roller operator (steam or gasoline).1.00 Bulldozer operator.1.00 Grader operator.1.00 per week Material checker and time-keeper.42.00 per hour Watchman, employed also as fireman and required to hold a 4th class certificate (without limitation of the daily hours of work \u2014 weekly maximum of 72 hours).1.05 Watchman on job (night and day, without limitation of the daily hours of work, weekly maximum of 72 hours).0.65 Doiler fireman, required to hold a 4th class certificate.1.00 Water carrier.0.80 Men committed to the ramming, smoothing and spreading of asphalt.0.90 Men committed to the piping, caulkers \u2022 and welders.0.90 2.Subsection \"6\" of section IV will be replaced by the following: b) Travelling expenses of employees sent outside the City of St.John and the Town of Iberville shall be paid by the employer without wage deduction.Besides, the noon meal shall be paid by the employer if the employee has not been notified the day before. 956 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1951, Tome 88, N° 11 Les frais de pension doivent également être payés si les salariés ne sont pas ramenés chaque soir dans lesdites < ité et ville.\" 3* Le paragraphe \"e\" de l'article VI sera radié.4° L'article XI-A suivant sera ajouté: v \"XI-A.Congés payés: a) Définitions: Les termes ci-après mentionnés ont, à moins d'incompatibilité, le sens qui leur est ci-après donné: Employeur: Une personne employant un salarié régi par le présent décret; Commission: La Commission du Salaire minimum; Livret de congés: Un livret émis par la Commission, aux 6ns d'y apposer durant une période de prestations, des timbres de congés payés; Période de prestation: La période s'étendant du premier mai d'une année au trente avril de l'année suivante; Timbres: La marque imprimée ou vignette émise par la Commission pour représenter les prestations de congés ducs par un employeur.6) Droits du salarié: 1.aux congés payés: Tout salarié régi par le présent décret, ayant été au service continu d'un employeur durant une période de prestation, a droit, à la fin de telle période, à un congé d'une durée minimum de sept jours consécutifs et à la rémunération pour congés ci-après fixée; 2.à rémunération pour congés: Tout salarié régi par le présent décret, n'ayant pas été au service continu d'un employeur durant une période de prestations, a droit, à la fin de telle période, seulement, à la rémunération pour congés ci-après fixée.c) Prise de congé: L'employeur doit donner à son salarié y ayant droit, le congé prévu par le Swésent article, dans les quatre mois qui suivent a date de la fin d'une période de prestations.d) Rémunération pour congés: La rémunération pour congés à laquelle à droit un salarié régi par le présent décret représente, pour une période de prestations, la valeur des timbres apposés, pour telle période, dans son livret de congés.e) Apposition de timbres: Tout employeur doit, apposer à l'échéance de chaque paie de son salarié, dans le livret de congés de ce dernier des timbres pour une valeur égale à deux pour cent (2%) du montant brut de telle paie./) Obligations de l'employeur: Tout employeur doit: 1) se procurer de la Commission avant le commencement d'une période de prestations, un livret de congés pour chacun de ses salariés; 2) exiger de tout salarié embauché au cours d'une période de prestations, la remise de son livret de congés et, s'il n'en possède pas, lui en procurer un; 3) conserver jusqu'à la fin d'une période de prestations ou, s'il y a résiliation antérieure du contrat de travail, durant le temps d'emploi, les livrets de congés de chacun de ses salariés; ' 4) remettre à chacun de ses salariés à la fin d'une période de prestations ou lors de la résiliation antérieure de son contrat de travail, son livret de congés.L'employeur qui fournit à un salarié un livret de congés payés peut en déduire le coût du salaire de ce dernier.Board shall also be paid by the employer when the employees are not taken back every night in the said city and town.\" 3.Subsection \"e\" of section VI will be deleted: 4.The following section XI-A will be added: \"XI-A.Vacation with pay: a) Definitions: Barring incompatibility, the following words have the meaning hereinafter given to them: Employer: Any person hiring an employee governed by the present decree; Commission: The Minimum Wage Commission; Vacation-with-pay stamps book: A book issued by the Commission for the purpose of affixing therein, during a vacation-with-pay credit period vacation-with-pay credit stamps; Vacation-with-pay credit period: The period extending from the 1st of May of one year to the 30th of April of the next year; Vacation-with-pay credit stamps: The printed mark or stamp issued by the Commission, representing the vacation-with-pay credit payable by an employer; b) Rights of the employee: 1.to a vacation-with-pay: Every employee governed by the present decree, whose work has been continuous with one employer throughout a vacation-with-pay credit period, is entitled, at the end of such period, to a vacation having a minimum duration of seven consecutive days and to the vacation credit hereinafter determined; 2.to a vacation credit' Every employee governed by the present decree, whose work has not been continuous with one employer thoughout a vacation-with-pay credit period, is entitled,- at the end of such period, only to the vacation credit hereinafter determined.c) Period during which vacation is to be given: The employer must give, whithin four months from the date of expiration of a vacation-with-pay credit period, the vacation to which an employee is entitled according to the present section.d) Vacation credit: The vacation credit to which an employee governed by the decree is entitled represents, for a vacation-with-pay credit period, a sum of money equivalent to the face value of the stamps affixed in his vacation-with-pay stamp book, for said credit period.e) Affixing of stamps: Every employer, at the end of each regular pay period, must affix in his employee's vacation-with-pay stamp book vacation-with-pay credit stamps in an amount equivalent to two per centum (2%) of the gross amount of such pay./) Employer's obligations: Every employer must 1) obtain from the Commission a vacation-with-pay stamp book for each of his employees, before the beginning of a vacation-with-pay credit period; 2) require from every employee hired during a vacation-with-pay credit period, the remittance of his vacation-with-pay stamp book and, should he not possess such book, provide him with one; 3) keep each employee's vacation-with-pay stamp book till the end of the vacation-with-pay credit period, or, during the time of employment, should the employee's labour contract be previously cancelled; 4) give back his vacation-with-pay stamp book to each one of his employees, at the' end of a vacation-with-pay credit period or at the time of the previous cancellation of his labour contract.The employer who provides his employee with a vacation-with-pay stamp book may deduct from the employee's wages the cost of such book. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 957 g) Obligations du salarié: Tout salarié doit: 1) remettre sans délai son livret de congés à l'employeur qui l'engage au cours d'une période de prestations; 2) réclamer de l'employeur qui l'emploie, son livret de congés à la fin d'une période de prestations ou lors de la résiliation antérieure de son contrat de travail.h) Remboursement de la rémunération: Tout salarié a le droit de réclamer de la Commission, à la fin d'une période de prestations, le remboursement des timbres apposés dans son livret de congés pour telle période.t) Propriété du livret de congés payés: Le livret de congés bien qu'il puisse être en la possession de l'employeur, est la propriété du salarié; la créance qu'il constate est incessible.j) Convention interdite: Est expressément interdite toute stipulation d'un contrat accordant à un salarié régi par le présent décret, des conditions moins avantageuses que celles fixées au présent article.\" 5° Le paragraphe \"k\" de l'article XII sera remplacé par le suivant: \"k) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux apprentis des métiers ci-après mentionnés: Taux horaires 1.\u2022Charpentier-menuisier, peintre, asper- geur, vitrier, décorateur, tapissier et vernisseur: 1ère année.$0.75 2ème année.0.80 3ème année.0.85 4ème année.0.95 2.Électricien, plombier, poseur d'appa- reils de chauffage, mécanicien en tuyauterie, soudeur en tuyauterie, ouvrier-tôlier et ferblantier-couvreur: 1ère année.0.75 2ème année.0.85 3ème année.0.90 4ème année.0.95 3.Briqueteur, maçon, plâtrier: 1ère année.0.95 2ème année.1.00 3ème année.1.05 4ème année.;.1.20 4.Poseur de brûleurs à l'huile: 1ère année.0.85 2ème année.:.0.95\" 6° L'article XIV sera remplacé par le suivant: \"XTV.Durée du décret: Le présent décret est valable à compter de la date de sa publication, dans la Gazette officielle de Québec, et demeure en vigueur jusqu'au 30 avril 1952! Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite à moins que l'une des parties contractantes, ne donne à l'autre partie un avis écrit à se contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 30 avril de chaque année.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 17 mars 1951.29704-o g) Employee's obligations: Every employee must 1) without delay, give back his vacation-with-pay stamp book to the employer who hires him during a vacation-with-pay period; 2) at the end of a vacation-with-pay credit period or at the time of the previous cancellation of his labour contract claim his vacation-with-pay stamp book from the employer who hires him.h) Redemption of stamps: Every employer at the end of a vacation-with-pay credit period, has the right to claim from the Commission the redemption of the stamps affixed for such period in his vacation-with-pay stamp book.i) Ownership of the vacation-with-pay stamp book: Though in the employers' hands, the vacation-with-pay stamp book belongs to the employee, and .the credit shown therein is untransferable.j) Forbidden agreement: Any stipulation of a labour contract for the purpose of granting to an employee governed by the decree, conditions less advantageous than those fixed in the present section is strictly forbidden.5.Subsection \"&\".of section XH will be replaced by the following: \"k) The following minimum wage rates shall be paid to apprentice of the trades hereafter mentioned: Hourly rates 1.Carpenter-joiner, painter, sprinkler fitter, glazier, decorator, paper hanger and varnisher: 1st year.$0.75 2nd year.0.80 3rd year.0.85 4th year.0.95 2.Electrician, plumber, steamfitter, pipe mechanic, pipe welder, sheet-metal worker and tinsmith-roofer: .1st year.0.75 2nd year.0.85 3rd year.0.90 4th year.0.95 3.Bricklayer, mason, plasterer: 1st year.0.95 2nd year.1.00 3rd year.1.05 4th year.1.20 4.Oil burner fitter: 1st year.0.85 2nd year.0.95\" 6.Section XIV will be replaced by the following: \"XIV.Duration of the decree: The present decree will come into force the day of its publication in the Quebec Official Gazette and shall remain in force until April 30.1952, It then renews itself automatically, from year to year, unless one of the contracting parties notify the other party, in writing, to the contrary within a /lelay not to exceed sixty (60) days, nor to be less than thirty (30), before April 30 of each year.Such a notice must also be sent to the Minister of Labour.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 17, 1951.29704-o 958 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quêwc, 17 mars 1951, Tome 83, N° 11 Et, d'autre part: \"The Sheet Metal Workers International Association, Local 116\"., .pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions ci-après décrites: And, on the other part: The sheet Metal Workers International Association, Local Union No.116.for the employers and the employees of the industry and trades concerned, according to the following conditions: I.Definitions: Tour les fins d'application du I.Definitions: For the purpose of enforcement décret, les mots et termes suivants ont la signi- of thé decree, the following words have the fication qui leur est ci-après donnée: meaning hereinafter given to them: a) Le terme \"sous-contremaitre\" désigne un a) Assistant Foreman shall be an employee salarié nommé par son employeur à cette position appointed by his employer to such position and et dont les fonctions sont d'aider le contremaître his functions shall be to assist the Foreman in dans l'exécution de son travail régulier.the execution of his regular duties.b) Le terme \"chef d'équipe\" désigne un méca- b) A charge hand shall be a mechanic in charge nicien chargé de l'exécution d'un travail et, qui of the fabrication of a job and who has a group a un groupe de salariés travaillant sous sa juri- of men working under his direction.diction.c) Le terme \"mécanicien en métal en feuille\" c) A sheet metal mechanic shall be an employee désigne tout salarié qualifié qui peut lire ' les skilled in his trade, competent to work from plans et exécuter, d'après les dessins, toute spé- drawings and carry out the fabrication of sheet ration relative à la fabrication du métal en feuille metal and allied materials without direction et des métaux similaires, sans aide ou surveil- from others.lance.d) Soudeurs: 1 ° Le terme \"soudeur classe A\" d) Welders: 1.A Class \"A\" welder is an em-désigre tout salarié possédant une connaissance ployee with complete knowledge of either oxy-complète de la soudure acétylène ou électrique acetylene of electric arc welding of .all sheet metal de tout métal en feuille ou des métaux similaires and allied materials, competent to work directly et pouvant exécuter lui-même, d'après les plans from drawings and specifications and able to et devis toutes les opérations de son métier, carry out operations in his trade without direc-sans aide ou surveillance.tion from others.Nate: Un soudeur qualifié en vertu de Parti- Note: A welder qualified under article 25 of cie 25 des règlements en exécution de la loi des the regulations for carrying out of the Pressure Appareils sous pression et approuvés par le Un- Vessels Act and as approved under the \"Unfired fired Pressure Vessel Code, édition 1943, doit Pressure Vessels Code, .1943 Edition\", shall be être considéré comme un soudeur de la classe \"A\", classified as a Class \"A\" Welder.2° Le terme \"soudeur classe \"B\" désigne tout 2.A class \"B\" welder is an employee with salarié possédant une connaissance complète de complete knowledge of either oxy-acetylene or la soudure acétylène ou électrique du métal en electric arc welding of sheet metal and allied feuille ou des métaux similaires et pouvant exé- materials and competent to work directly from cuter, d'après les plans et devis, les opérations detailed drawings and able to carry out opera- de son.métier, selon les instructions qu'il reçoit, tiens in his trade with direction from others.3° Le terme \"soudeur classe C désigne tout 3.A class \"C\" welder is an employee with salarié possédant une certaine connaissance de knowledge of either oxy-acetylene or electric arc la soudure acétylène ou de la soudure électrique welding of sheet metal and allied materials and du métal en feuille et des métaux similaires el competent to carry out operations in \u2022his trade pouvant exécuter les opérations de son métier under supervision, selon les instructions qu il reçoit.4° Le terme \"soudeur en série\" désigne tout 4.A \"production welder\" is a workman em- salarié affecté à un travail de routine en soudure ployed on routine welding operations and whose dont le taux de salaire est automatiquement rate shall be increased automatically as indi- majoré de la façon indiquée à l'article VII.* cated in section VII.e) Machiniste: 1° Le terme \"machiniste- e) Machinist: 1.A \"Machinist Mechanic\" shall mécanicien\" désigne tout salarié qualifié possé- be an employee with full knowledge of machine dont une connaissance complète de la machinerie shop practice and competent to work directly et pouvant' exécuter sur plans et devis toutes les from drawings and specifications and to carry out opérations de son métier, sers aide ou surveillance any operations in his craft without direction from others.2° lie mot \"machiniste\" désigne tout salarié 2.A \"Machinist\" shall be an employee with qualifié possédant une connaissance complète de full knowledge of machine shop practice and la machinerie et pouvant exécuter sur plans et competent to work directly from drawings and devis toutes les opérations de son métier, sous sur- specifications and to carry out any operations^ veillance.his craft with direction from others.| & AVIS NOTICE L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister Travail, donne avis par les présentes, conformé- of Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Loi de la Convention provisions of the Collective Agreement Act, that collective (Statuts refondus de Québec 1941, the contracting parties hereafter mentioned have chapitre 163 et amendements), que les parties ci- submitted to him a request to render obligatory après mentionnées lui ont présenté une requête the collective labour agreement entered into à l'effet de rendre obligatoire la convention col- between: lective de travail intervenue entre: D'une part: On the one part: La Chambre de Construction Inc., Section de The Builder's Exchange Inc., Sheet Metal la fabrication du métal en feuilles, Fabricating Section. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 17th, 1951, Vol.83, No.11 959 /) Le mot \"outilleur\" désigne tout salarié spécialisé dans la fabrication des poinçons, guides et outils.L'outilleur doit être capable de produire ces articles d'après les dessins ou esquisses en employant l'outillage régulier de l'atelier, sans aide ou surveillance.g) Le terme \"compagnon peintre\" désigne tout salarié qui a toute l'expérience voulue pour peinturer les métaux et autres matériaux de même nature, soit au pinceau, au pistolet ou par immersion et pour faire le nettoyage et la cuisson nécessaire.Il doit pouvoir préparer les couleurs et mélanger sa propre peinture et avoir été engagé spécifiquement comme peintre.h) Le terme ''peintre au pistolet\" désigne tout salarié travaillant durant au moins 70% de son temps à peinturer au pistolet et qui peut mélanger la peinture utilisée pour cette opération et prendre soin du pistolet.t) Le mot \"forgeron\" désigne tout salarié capable d'exécuter le travail appartenant au métier de forgeron.j) Les mots \"préposé aux machines\" désignent tout salarié capable de monter et d'ajuster sa machine pour les opérations ordinaires à exécuter et de voir au fonctionnement de sa machine d'une façon compétente.Les préposés à la cisaille mécanique, à la plieuse et découpeuses mécanique ou à la machine à rouler (roll foiming)\u2014à l'exception de la machine à ourler (lock former) Pittsburgh\u2014seront considérés comme préposés aux machines.k) Les mots \"assembleur\" et \"ouvrier spécialisé\" désignent tous salariés qui peuvent exécuter toute opération d'après les instructions, lire les détails apparaissant sur les plans et exécuter des travaux requérant moins de compétence que ceux qu'exécutent les ouvrieis qualifiés.I) Le terme \"ouvrier de la production désigne tout salarié qui, ayant reçu l'eut raine mer t réces-saire, exécute du travail ayant trait à la fabrication en série, lequel requiert moins d'expérience que celui des assembleurs et ouvriers spécialisés; tel salarié n'est pas requis de lire les détails sur les plans.Par \"fabrication en série\", on entend une fabrication qui nécessite la répétition des mêmes opérations plusieurs fois durant la même journée.m) Le terme \"chef de groupe\" désigne tout salarié qui n'est pas un mécanicien et qui est chargé de la direction d'un groupe d'hommes en vue de l'exécution d'instructions déterminées tombant sous le coup de sa propre classification ou d'une classification inférieure.n) Aides: Les aides sont des salariés qui assis tent et qui aident les ouvriers qualifiés appartenant à une classification supérieure à celle des ouvriers de la production.o) Apprentis: Les apprentis sont des garçons ou jeunes gens de 16 à 21 ans; ils reçoivent un carnet d'apprentissage du Comité paritaire.Ce carnet doit être dûment rempli par les employeurs avec mention des périodes de travail dans le métier.p) Garçons: Les garçons de 16 à 18 ans inclusivement peuvent être affectés à un travail de routine, aux taux établis pour les apprentis dans le paragraphe \"t\" de l'article VII, jusqu'à ce qu'ils atteignent le taux régulier des aides.Par travail de routine, on entend le travail des messagers, des commissionnaires ou autre occupation de semblable nature.Si un garçon est placé dans une autre class-fication, il doit être rémunéré en conséquence.Les garçons autres que ceux affectés à un travail de routine ne peuvent, toutefois, dépasser en nombre de cinquantième des salariés de l'établissement./) A \"Toolmaker\" shall be an employee engaged in the fabrication of dies, jigs and tools.He shall be capable of producing these from working drawings or sketches, using standard tool room equipment, without direction from others.g) A \"Journeyman Painter\" shall be an employee who is thoroughly experienced in painting metal and allied materials by brush, spray and dipping methods, and in the cleaning and baking procedure necessary.He shall be competent to blend colors and mix his own paint, and shall have been employed specifically as a painter.h) A \"Spray Painter\" shall be an employee engaged a minimum of 70% of his time in spray painting and capable of mixing the paint to be used in said operation and of taking care of the spray gun.t) A \"BalcksmUh\" shall be an employee capable of doing the usual work appertaining to the trade of balcksmith.j) A \"Machine Operator\" shall be an employee competent to set up and adjust his machine for ordinary operations to be permormed and to operate his machine in a skillful manner.Workmen who operate a power shear, power brake or roll forming machine (with the exception of Pittsburg Lock Former) .shall be classified as a Machine Operator.k) \"Assemblers and Specialists\" shall be employees competent to carry out operations according to instructions, and shall be able to read detailed drawings and engage in work requiring less skill than a journeyman.I) \"Production Workers\" shall be employees occupied under supervision in repetitive work that requires less skill than the qualifications of assemblers and specialists; they shall not be required to read detailed drawings.The words \"repetitive work\" shall mean repeated operations several times a day.m) A \"leading hand\" shall be an employee who is not a mechanic and who is handling a groupe of men to carry out specific instructions within the scope of his own or a lesser classification.n) \"Helpers\" shall be employees occupied to help and give useful assistance to a more experienced workman classified above the classification of production workers.o) \"Apprentices\" shall be boys or young men between the ages of sixteen and twenty-one and they shall receive an apprenticeship book from the Joint.Committee.Said book shall be properly filled by employers, crediting time worked at trade.p) Boys: Boys between the ages of 16 and 18 inclusively may be employed for routine operations at the rates set for apprentices in section VH-i until such time as they acquire the standard rate for helpers.Routine operations shall comprise such work as messengers, stock-chasers and the like.If a boy be placed in any other classification he shall be paid accordingly.Boys others than those employed on routine operations may, however, be employed at a ratio not greater than one to every 50 employees in the plant. 960 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 17 mars 1961, Tome 83, N° 11 g) Divers: Les salariés employés régulièrement comme expéditeurs, hommes d'entrepôts ou mug;'.ni iers doivent recevoir $0.051 heure de plus que le taux mi,- imum des aides.Le salarié en charge de ces départements doit recevoir $0.15 l'heure de plus que le taux mi; imum des aides.Toutefois, les salariés employés temporairement à ces fonctions continuent de recevoir leurs taux réguliers de salaire.r) I-e terme \"polisseur classe A\", désigne un salarié qui polit des métaux et alliages de formes variées s°j.s en altérer la forme et les contours; prépare les colles et autres bases adhérentes choisit les différents abrasifs; forme et ajuste les meules en vue d'obtenir un rendement uniforme.JJ.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend l'Ile de Montréal et un rayon de quinze (15) milles de ses limites.HJ.Juridiction industrielle et -professionnelle: a) Le décret s'applique à tous les établissements s'occupant de la fabrication des produits de métal en feuille.Les produits de métal en feuille comprennent tout matériel usiné ou article fabriqué entièrement ou en majeure partie de métal en feuille d'une épaisseur variant de .0043 de pouce à .1875 de pouce.Le métal en feuille désigne l'acier et le fer ainsi que tout métal non-ferreux ou alliage.6) Le décret ne s'applique pas aux établissements industriels et à leurs salariés déjà régis par une convention collective de travail rendue obligatoire par décret, en vertu de ladite Loi,' ni à la fabrication des poêles ct/ou des fournaises dans les fonderies reconnues comme telles.IV.Durée du travail: a) La semaine régulière de travail est de quarante-deux (42^) heures et demie.La durée journalière re doit pas excéder huit heures et demie (8J^), sans determination des heures de commencement et de cessation du travail.6) Déductions pour retard: 1° Horloge de présence à la minute: Une déduction de quinze (15) minutes est imposée pour tout retard excédant trois minutes par quart d'heure sur les horloges qui enregistrer.t les minutes, i.e.pour les retards de quatre (4) à dix-huit (18) minutes, la déduction est de quinze (15) minutes; pour les retards de dix-r.eufs (19) à trente-trois (33) minutes, la déduction est d'une demi-heure et ainsi de suite.2° Horloge de présence au dixième d'heure: Dans les établissements où ces horloges sont en usage, les salariés doivent poinçonner leur temps dans les six minutes qui précèdent l'heure fixée pour le commencement du travail et dans les six (6) minutes qui suivent la cessation du travail.La déduction imposée pour les retards en regard de ce système est la suivante: quinze (15) minutes pour les retards d'un ou deux points (6-12 minutes) et une demi-heure pour les retards de trois, quatre\"et cinq points (18-24-30 minutes).V.Travail supplémentaire: a) Tout travail exécuté en plus de huit heures et demie (8)^) par jour et tout travail exécuté le samedi est considéré comme du travail supplémentaire.6) Tout travail supplémentaire doit être rémunéré au taux de salaire et demi'par rapport au salaire régulier.c) Le double du taux de salaire régulier doit être payé pour tout travail exécuté les dimanches et les jours de fête suivants: Le Premier de l'An, ie Vendredi-Saint, le 24 mai, la fêle de la Çonfé-
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.