Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 mars 1951, samedi 24 (no 12)
[" Tome 83, N° 12 983 Vol.83, No.12 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubushed by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 24 mars 1951\tQuebec, Saturday, March 24th, 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1° Adresser toute correspondance à: ITmpri- 1.Address all communications to: The King's meur du Roi, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, \"d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui will be suspended without further notice and rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme without préjudice as regards the rights of the versée en plus.King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat the'King's Printer, by accepted cheque, by bank de banque ou mandat-poste.or postal'money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa.Canada.wa, as second class mailable matter. 984 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A mars 1951, Tome 83, N° 12 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois .derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour tics raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.' 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre, \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u2014 1-52 Lettres patentes Bélanger Bowling Alley & Restaurant Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux février 1951, constituant en corporation: Sam Genser, marchand, Norman Genser et Syndey Phillips, tous deux avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un restaurant et d'une salle de quilles, sous le nom de \"Bélanger Bowling Alley & Restaurant Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of.administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of.insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u20141-52 Letters Patent Bélanger Bowling Alley & Restaurant Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of February, 1951, incorporating: Sam Genser, merchant, Norman Genser and Sydney Phillips, both advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant and bowling alley, under the name of \"Bélanger Bowling Alley & Restaurant Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 390 preferred shares having a par value of $100.each, and 1,000 common shares having a par value of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March SAth, 1951, Vol.83, No.12 985 Bonnie Lingerie Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux février 1951, constituant en corporation: Charles-H.Desjardins, Edward G.Tannage, avocats et Jeannette Desjardins, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et autrement faire le commerce de sous-vêtements, lingerie et vêtements de sport pour dames et enfants, sous le nom de \"Bonnie Lingerie Limited\", avec un capital.de $75,000 divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.B & L Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du huit février 1951, constituant en corporation: Armand Lavallée, notaire, Micheline Lavallée, ménagère, et Marcelle Lavallée, secrétaire, toutes deux filles majeures, tous de la cité de Joliette, district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille et de placement, sous le nom de \"B & L Investment Corporation\", avec un capital de $150,000 divisé en 100,000 actions Classe A de $1.chacune et en 50,000 actions Classe B de $1.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o 9 L.DÉSILETS.Canadian Armature Works Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du six février 1951, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi du Roi, Jean McFarlane, dactylographe, tous deux de la cité de Montréal et Théodore Herzl Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme mécaniciens, marchands et manufacturiers d'outillages, moteurs et autres machineries, sous le nom de \"Canadian Armature Works Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Bonnie Lingerie Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of February, 1951, incorporating: Charles-H.Desjardins, Edward G.Tannage, advocates, and Jeannette Desjardins, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and otherwise deal in ladies' and children's sunderwear, lingerie and sportswear, under the name of \"Bonnie Lingerie Limited\", with a capital stock of $75,000.divided into 400 common shares with a par value of $100.each, and 3,500 preferred sluues with a par value of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of tlie Attorney General, this second day of February, 1951.L.DÉSILETS, s 29709-o Deputy Attorney General.B & L Investment Corporation Notice is hereby given tliat under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Armand Lavallée, notary Micheline Lavallée, housekeeper and Marcelle Lavallée, secretary, both spinsters, all of the city fo Joliette, judicial district of Joliette, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company under the name of \"B & L Investment Corporation\", with a capital stock of $150,000, divided into 100,000 Class A shares of $1 each, and 50,000 Class B shares of $1 each.The head office of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Canadian Armature Works Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixth day of February, 1951, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Jean McFarlane, typist, both of the City of Montreal, and Theodore Herzl Shapiro, advocate, of the Town of Mount Royal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of mechanics and dealers in and manufacturers of plants, engines and other maclunery, under the name of \"Canadian Armature Works Inc.\", with a capital ^tock of $100,000 divided into 100 common shares of a par value of $100.each: and 900 preferred shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General. 986 GAZETTE OFFICIELLE DE QIÊBEC, Québec, 2k mars 1951, Tome 83, N° 02 Canadian Athletic Promotions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, \u2022 chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit février 1951, constituant en corporation: Edmund Quinn, promoteur, de ville Mont-Royal, Louis Abraham DeZwirek, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Montréal, et S.Leon Mendelsohn, avocat de conseil en loi du Roi, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Diriger, exploiter et promouvoir les sports et divertissements d'été et d'hiver, sous le nom de \"Canadian Athletic Promotions Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 - L.DÉSILETS.Canadian Athletic Promotions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Edmund Quinn, promoter of the Town, of Mount Royal, Louis Abraham DeZwirek, advocate and King's Counsel, of the City of Montreal, and S.Leon Mendelsohn, advocate and King's Counsel of Westmount, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on, operate and promote summer and winter sports and amusements, under the name of \"Canadian Athletic Promotions Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Canadian Installment Merchants Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier février 1951, constituant en corporation sans capital-actions, Joe Socaransky, Bernard Berlin, Sydney dayman, Sam Wener, Jack Kahn, Solomon Braude-Joe Lipovenko, tous marchands de la cité de Montréal et Jack Rothstein, marchand, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Encourager l'amitié, la bonne entente, l'harmonie et la coopération entre les marchands dé détail à tempérament du district de Montréal et formuler et donner effet à des mesures de protection de leurs intérêts communs, sous le nom de \"Canadian Installment Merchants Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Ciné-Path Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieuteneant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq février 1951, constituant en corporation: Marc Leroux, notaire, de Ville Mont-Royal, Jean Racicot, notaire, et Gisèle Mercier, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'appareils, instruments et accessoires cinématographiques, photographiques, électriques de tout genre, sous le nom de \"Ciné-Path Inc.\", avec un capital de $25,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Canadian Installment Merchants Association Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of February, 1951, incor- Ëorating without share capital: Joe Socaransky, iernard Berlin, Sydney Clayman, Sam Wener, Jack Kahn, Solomon Braude, Joe Lipovenko, all merchants, of the City of Montreal, and Jack Rothstein, merchant, of the City of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote the friendliness, goodwill, harmony and cooperation among retail installment merchants of the District of Montreal, and to devise and give effect to measures for the protection of their common interest, under the name of \"Canadian Installment Merchants Association\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited is $25,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Ciné-Path Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of February, 1951, incorporating: Marc Leroux, notary, of the town of Mount Royal, Jean Racicot, notary, and Gisèle Mercier, secretary, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in moving-picture, photographic and electric equipment, machinery and accessories of all kinds, under the name of \"Ciné-Path Inc.\", with a capital stock of $25,000 divided into 500 common shares of a par value of $10 each, and 2,000 preferred shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Aih, 1951, Vol.83, No.12 987 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de Carolina-S t -Arsène Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Adélard Michaud, Félix Gagnon, cultivateurs, Paul Chouinard, chef de gare, Victor Abgral, gérant de tourbière, tous quatre de Cacouna, Paul-Emile Roy, marchand, Gérard Laforest, commerçant, et Jean-Baptiste Lebel, cultivateur, tous trois de Saint-Arsène, tous du district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Voir à l'entretien d'hiver de chemins, sous le nom de \"Comité d'Entretien des Chemins d'hiver de Cacouna-St-Arsène\".Le siège social de la corporation sera à Saint-Arsène, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1951.L'Assistant-procureur général, ¦ 29709-o L.DÉSILETS.Damien Boileau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente janvier 1951, constituant en corporation: Emé.Lacroix, C.R.avocat de Ville Mont-Royal, Jacques Viau, avocat, de Lachine, et Paula Boisvert, sténographe, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme contracteur et constructeur général, sous le nom de \"Damien Boileau Inc.\", avec un capital de $300,000, divisé en 2,500 actions privilégiées de $100 chacune et en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.> Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Delta Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des\" lettres patentes en date du vingt-neuf janvier 1951, constituant en corporation: Seymour Elkin, notaire, de la cité de Westmount, Stanley Stanger, officier d'une.compagnie de fiducie, de la ville de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme soudeurs, fabricants d'outils, maîtres de forge, fabricants d'acier, convertisseurs de fer et d'acier, raffineurs, fondeurs en fer, fondeurs en bronze, travailleurs en métal, machinistes, forgerons, fabricants de patrons, métallurgistes, fabricants de bouilloires, The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de Cacouna-St-Arsène Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1951, to incorporate a corporation without share capital: Adélard Michaud, Félix Gagnon, farmers, Paul Chouinard, station-master, Victor Abgral, peat-bog manager, all four of Cacouna, Paul-Èmile Roy, merchant, Gérard Laforest, trader, and Jean-Baptiste Lebel, farmer, all three of Saint-Arsène, all of the judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To attend to the winter maintenance of roads, under the name of \"Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de Cacouna-St-Arsène\" The head office of the corporation will be at Saint-Arsène, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Damien Boileau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the.Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of January, 1951, incorporating: Emé.Lacroix, K.C., advocate, of the Town of Mount Royal, Jacques Viau, advocate, of Lachine, and Paula Boisvert, stenographer, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as general contractor and builder, under the name of \"Damien Boileau Inc.\", with a capital stock of $300,000, divided into 2,500 preferred shares of $100 each and 5,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Delta Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of January, 1951, incorporating: Seymour Elkin, notary of the City of Westmount, Stanley Stanger, trust company officer, of the Town of Hampstead, and Ralph C.Tees, trust company officer of the Town of Hampstead, and Ralph C.Tees, trust company officer of Westmount, all in the Judicial District of Mont-treal, for the following purposes: To carry on the business of welders, tool-makers, iron-masters, steel-makers, iron and steel converters, smelters, iron-founders, brass-founders, metal-workers, machinists, smiths, 988 GAZETTE OFFICIELLE DE QLÉBEC, Québec, 2L mars 1951, Tome 88, N° 12 travailleurs en bois, propriétaires de moulin, constructeurs, peintres, travailleurs en électricité, sous le nom de \"Delta Industries Ltd.\", avec un capital de S 10,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune et en 1,000 actions privilégiés d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9 avenue Willow, cité de Westmount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier 1951.- L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.model-makers, metallurgists, boiler-makers, woodworkers, millwights, builders, painters, electrical workers, under the name of \"Delta Industries Ltd.\", with a capital stock of 810,000.divided into 1,000 common shares of a par value of $5.each and 1,000 preferred shares of a par value of $5.each.The head office of the Company will be at 9 Willow Avenue, in the City of Westmount, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Douville Drilling Inc.Douville Drilling Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part.I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.Alfred Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.It.Q.1941, des lettres patentes en date 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth du dix-sept février 1951, constituant en corpora- 'day of February, 1951, incorporating: Conrad tion: Conrad Douville, industriel, Jean-Marc Douville, industrialist, Jean-Marc Roberge, no-Roberbe, notaire, Gabriel Roberge, avocat, tary, Gabriel Roberge, lawyer, Philippe Roberge, Philippe Roberge, notaire, et Laurent Turcotte, notary, and Laurent Turcotte, accountant, all comptable, tous de la cité de Thetford-Mines, of the City of Thetford Mines in the Judicial district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets District of Arthabaska, for the following pursuivants: poses: Exercer le commerce comme foreurs et trou- To carry on the business of drillers and mine veurs de mines, sous le nom de \"Douville Drilling locators, under the name of \"Douville Drilling Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 100,- Inc.\", with a capital stock of $100,000.divided 000 actions de $1 chacune.into 100,000 shares of $1.each.Le siège social de la compagnie sera à Thetford- The head office of the Company will be at Mines, district judiciaire d'Arthabaska.Thetford Mines, Judicial District of Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le dix- Dated at the office of the Attorney General this sept février 1951.seventeenth day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29709 L.DÉSILETS.29709-o Deputy Attorney General.Egger (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux février 1951, constituant en corporation: Almanzor Laberge, comptable, Andrée Lavoie, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, et Contran Daoust, comptable, de Saint-Vincent de Paul, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, importer, acheter et vendre des produits chimiques, des médicaments, remèdes, drogues, spécialités pharmaceutiques et en général de tous les articles vendus dans les phar-meies, sous le nom de \"Egger (Canada) Ltd.\", Le capital-actions de la compagnie est divise en 3,000 actions communes ou ordinaires sans valeur au pair ou nominale et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, et la compagnie commencera ses opérations avec au moins $20,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Élie & Son Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, iPa été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Egger (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the \"second day of February, 1951, incorporating: Almanzor Laber,-ge, accountant, Andrée Lavoie, secretary, both of the city of Montreal, and Gontran Daoust, accountant, of Saint-Vincent de Paid, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, import, buy and sell chemical products, medicines, remedies, drugs, pharmaceutical specialties and generally all articles sold in drug stores, under the name of \"Egger (Canada) Ltd.\" The capital stock of the company is divided into 3,000 common or ordinary shares having no par or nominal value and into 500 preferred shares of a par value of $100 each, and the company will commence operations with at least $20,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Élie & Son Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March gAtk, 1951, Vol.83, No.12 989 Morisset, conformément à l'article 2, chapitre Morisset, in conformity with section 2, chapter 276,-S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date 276, R.S.Q., 1941, hearing date the thirty-first du trente et un janvier 1951, constituant en cor- day of January, 1951, incorporating: D.Rodolphe poration: D.-Rodolphe Elie, gérant général, C- Élie, general manager, C.Roger Éiic, accoun-Roger Élie, comptable, et Horace Elie, profes- tant, and Horace Elie, professor, all of the city seur, tous des cité et district judiciaire de Mont- and judicial district of Montreal, for the follow-real, pour les objets suivants: ing purposes: Exercer le métiers, commerce ou industrie, To carry on the trades, business, or industry comme plaqucurs, manufacturiers, travailleurs of platers, manufacturers, electrolytic and chem-au moyen de procédés électrolytiques et chimi- ical process workers, converters and repairers of ques, convertisseurs et réparateurs de toutes all kinds and types of metals, metal products, sortes et de tous genres de métaux, produits mineral wood and other natural products, and as métalliques, minéraux, bois et autres produits \\ machinists, smelters and smiths, under the name naturels, et comme machinistes, fondeurs et for- of \"Élie & Son Inc.\", with a capital stock of gérons, sous le nom de \"Élie & Son Inc.\", avec 850,000 divided into 250 common shares of un capital de 850,000 divisé en 250 actions com- 8100 each and 250 preferred shares of 8100 each, munes de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le trente Dated at the office of the Attorney General, et un Janvier 1951.' this thirty-first day of January, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29709-o L.DÉSILETS.29709 * Deputy Attorney General.Emile Menai-d.Ltée Emile Ménard Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.Alfred Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, conformément à l'article, 2 chapitre Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, des lettres,patentes en date, 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day du huit février 1951, constituant en corporation: of February, 1951, incorporating: Joseph Mé- Joseph Ménard, entrepreneur de pompes funè- nard, funeral undertaker, Bruno Ménard, manager bres, Bruno Ménard, gérant, Jean de Carufel, Jean de Carufcl, accountant, all three of Côteau- comptable, tous trois du Côteau-de-Lac, Joseph- du-Lac, Joseph Blanchard, broker, of Verdun, A.Blanchard, courtier, de Verdun, et Gabrielle and Gabrielle Boutin, stenographer, of the city Boutin, sténographe, de la cité de Montréal, of Montreal, all of the judicial district of Mont- tous du district judiciaire de Montréal, pour real, for the following purposes: les objets suivants: Exercer l'industrie et faire le commerce du To engage in industry and carry on the lumber bois sous toutes ses espèces et en tous ses usages, business, under all its forms and all its uses, in en produits et en sous-produits et de toutes les products and by-products, and in anything in choses dans la fabrication desquelles entre le the manufacturing of which wood may enter, hois, sous le nom de \"Emile Ménard Ltée\", under the name of \"Emile Ménard Ltée\", with avec un capital de $150,000 divisé en 1,500 a capital stock of 8150,000.divided into 1,500 actions de $100 dhacune.of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Coteau- The head office of the company will be at du-Lac, comté de Soulanges, district judiciaire Côteau-de-Lac, county of Soulangcs, judicial de Montréal.district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le huit Dated at the office of the Attorney General, février 1951.this eighth day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 29709-o L.DÉSILETS.29709 Deputy Attorney General.Garage Lambert Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq février 1951, constituant en corporation: Raoul Lambert, Léo-'Paul Lambert et Guy Lambert, garagistes, tous d'Asbestos, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants : Faire le commerce de véhicules automobiles de tout genre, et accessoires, et celui de garagiste en général, sous le nom de \"Garage Lambert Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.¦« Le siège social de la compagnie sera à Asbestos district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le cinq ¦février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.k_DÉSILETS.Garage Lambert Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of February, 1951, incorporating: Raoul Lambert, Léo-Paul Lambert, and Guy Lambert, garage-keepers, all of Asbestos, judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: To deal in motor vehicles of every kind, and in accessories, and carry on a general garage business, under the name of \"Garage Lambert Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Asbestos judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General. 990 GAZETTE OFFICIELLE DE QliÊBEC, Québec, 21 mars 1951, Tome 83, N° 12 H.J.O'Connell Ready Mix Concrete Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2,.chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit février 1951, constituant en corporation: John Richard Hyde, Roland-Gérard Lefrançois, Jean-Jules Gadbois, Jean-Eugène Goulet, avocats et Robert John Forster, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers, marchands et négociants du ciment Portland, toutes sortes de ciment naturel ou autres, plfitres et pierres artificielles, sous le nom de \"H.J.O'Connell Ready Mix Concrete Ltd.\", avec un capital de $202,000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8,200 rue Hochelaga, Montréal, district- judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 DÉSILETS.H.J.O'Connell Ready Mix Concrete Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day -of February, 1951, incorporating: Jolm Richard Hyde, Roland-Gérard Lefrançois, Jean-Jules Gadbois, Jean-Eugène Goulet, advocates, and Robert John Forster, accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in and with Portland cement, all kinds of natural and other cement and other plasters and artificial stone, under the name of \"H.J.O'Connell Ready Mix Concrete Ltd.\", |with a capital stock of $202,000.divided into 2,000 common shares of $1.each, and 2,000 preferred -shares of $100.each.The head office of the Company will be at 8,200 Hochelaga Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of ^February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Huron Fur Dressers Limited Apprêteurs de Fourrure Huron, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux février 1951, constituant en corporation: Roland Joncas, industriel, Camille Rhéau-me, négociant, et J.-Olivier Martin, gérant d'affaires, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de peaux vertes et tous les produits du cuir, de la laine, de la fourrure, sous le nom de \"Huron Fur Dressers Limited\"\u2014 \"Apprêteurs de Fourrure Huron, Limitée\".Le capital-actions de la compagnie sera composé de 2,000 actions communes sans valeur au pair et de 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune^ Le montant du capital-actions avec lequel la compagnie pourra commencer ses opérations sera de $13,000.Le siège social de la compagnie sera à Loret-teville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le deux février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.J.A.St-Laurent Motor Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un janvier 1951, constituant en corporation: Joseph-Amable St-Laurent, gérant, Bernard Villeneuve, comptable, tous deux de Montréal, Armand-H.Viau, comptable, Georges Vincent, comptable, de Verdun, et Laurel Mauf-fette, comptable, de Pointe-Claire, tous dû district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce en général de véhicules automobiles et le commerce de garagiste en général, sous le nom de \"J.A.St-Laurent Motor Sales Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé Huron Fur Dressers Limited Apprêteurs de Fourrure Huron, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of February, 1951, incorporating: Roland Joncas, industrialist, Camille Rhéaume, merchant, and J.Olivier Martin, business manager, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in rawhides and in all leather, wool and fur products, under the name of \"Huron Fur Dressers Limited\"\u2014\"Apprêteurs de Fourrure Huron, Limitée\".The capital stock of the company is composed of 2,000 common shares without par value and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The amount of capital stock with which the company may begin its operations is $13,000.The head office of the company will be at Lo-retteville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.J.A.St-Laurent Motor Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1951, incorporating: Joseph Amable St-Laurent, manager, Bernard Villeneuve, accountant, both of Montreal, Aramand H.Viau, accountant, Georges Vincent, comptable, of Verdun, and Laurel Mauffette, accountant of Pointe-Claire, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal generally in motor vehicles, and carry on a general garage business, under the name of \"J.A.St-Laurent Motor Sales Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 100 com- QbEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Atk, 1951, Vol.83, No.12 , 991 en 100 actions communes de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1951.~ L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.J.B.St-Pierre & Fils Inc.J.B.St-Pierre & Sons Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq février 1951, constituant en corporation: Albert St-Pierre, Roland St-Pierre et Jean-Baptiste St-Pierre, briqueteurs et plâtriers, de la ville de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exploiter les affaires d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"J.B.St-Pierre & Fils Inc.\" \u2014 \"J.B.St-Pierre & Sons Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.J.E.Tremblay Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six février 1951, constituant en corporation: Jean-Jacques Hamel, avocat, Maria-Anna Savard et Thérèse Trudeau, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de^Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois et de matériaux de construction, sous le nom de \"J; E.Tremblay Limitée\", avec un capital de $200,000 divisé en 20,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.John Spergel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf janvier 1951, constituant en corporation: John Spergel, marchand, Samuel Stein, avocat et Madeleine Brunet, veuve du feu Achille d'Arras, gérante de magasin, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de chaussures et vêtements de toute description, sous le nom de \"John Spergel Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.mon shares of $100 each, and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1951.L.DÊSDLETS, 29709 Deputy Attorney General.J.B.St-Pierre & Fils Inc.J.B.St-Pierre & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of February, 1951, incorporating: Albert St-Pierre, Roland St-Pierre, and Jean-Baptiste St-Pierre, bricklayers and plasterers, of the town of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on the business of general building contractors, under the name of \"J.B.St-Pierre & Fils Inc.\" \u2014 \"J.B.St-Pierre & Sons Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.J.E.Tremblay Limitée \u2022 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of February, 1951, incorporating: Jean-Jacques Hamel, advocate, Marie-Anna Savard and Thérèse Trudeau, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the lumber business and deal in building requisites under the name of J.E.Tremblay Limitée\", with a capital stock of $200,000 divided into 20,000 shares of $10 each.The capital stock of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.John Spergel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of January, 1951, incorporating: John Spergel, merchant, Samuel Stein, advocate, and Madeleine Brunet, widow of the late Achille D'Arras, store manager, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers in footwear and wearing apparel of every description, under the name of \"John Spergel Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of $100.each, and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General. 992 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A mars 1951, Tome 83, N° 12 Lachinc Figure Skating Club Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente janvier 1951, constituant en corporation sans capital-actions Cuthbert Stephens Saunders, ingénieur mécanicien, William Leonard Scott, agent de manufacturiers, et Charles Hense, imprimeur, tous de la cité de Lachine, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir, entretenir et diriger un club de patinage, sous le nom de \"Lachinc Figure Skating Club.\" Les pouvoirs accordé ne permettent pas la pratique des jeux d'argent de tout genre et, en particulier, ne permettent pas la direction ou la pratique de tout jeu de hasard ou de tout jeu mixte de hasard et d'habileté et ne permettent pas l'obtention ni l'exploitation d'un permis octroyé habituellement par la Commission des liqueurs de Québec.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Lake View Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux février 1951, constituant en corporation: William Henry Nightingale, fermier, de la paroisse de St-Dunstan du Lac Bcauport, Jeffery Dereck Martin, courtier d'assurances, de la cité de Québec et Bruce Norman Stewart, gérant de bureau, de Charlesbourg, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles; ériger des bâtisses et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Lake View Realty Co.Ltd.\", avec un capital de $10,000 divisé en 90 actions ordinaires de $100 chacune et en 10 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la paroisse de St-Dunstan du Lac Beauport, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Lachinc Figure Skating Club Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of January, 1951, incorporating without share capital: Cuthbert Stephens Saunders, mechanical engineer, William Leonard Scott, manufacturers' reprive, and Charles Hense, printer, all of the City of Lachine, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To establish, maintain, conduct a ' skating Club, under the name of \"Lachine Figure Skating Club\".The powers granted do not permit gambling practices of any nature and in particular do not permit the conducting or playing of any game of chance or any mixed game of chance and skill and do not permit the obtaining nor the operating of a license granted usually by the Quebec Liquor Commission.The amount to which the value of the immovable property which the corporation .may possess, is to be limited, is $25,000.The head office of the Corporation will be at Lachine, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Lake View Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of February, 1951, incorporating: William Henry Nightingale, farmer, of the Parish of St.Dunstan, of Lake Beauport, Jeffery^ Derek Martin, insurance broker, of the City of Quebec, and Bruce Norman Stewart, office manager, of Charlesbourg, all in the Judicial District of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company; to erect buildings and deal in building materials, under the name of \"Lake View Realty Co.Ltd.\", with a capital stock of $10,000.divided into 90 common shares of $100.each, and 10 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at the Parish of St.Dunstan of Lake Beauport, in the Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Larocque, Madore et Compagnie, Limitée Larocque, Madore et Compagnie, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit février 1951, constituant en corporation: Albert Madore, Lucien Larocque, marchands, Jean Ostiguy, comptale licencié, et Aldéi Mar-chesseault, commis, tous de Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Tenir hôtel, sous le nom de \"Larocque, Madore et Compagnie, Limitée\", avec un capital de Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Albert Madore, Lucien Larocque, merchants, Jean Ostigny, certified accountant, and Aldéi Marchesseault clerk, all of Drummondville, judicial district of, Arthabsaka, for the following purposes: To keep a hotel, under the name of \"Larocque, Madore et Compagnie, Limitée\", with a capital QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March tilth, 1951, Vol.83, No.12 993 $150,000 divisé en 7,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 7,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera sur le Boulevard Bernard, Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Dat£ du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o \u2022 L.DÉSILETS.L'Association des Hôteliers Licencies du Nord-Ouest Québécois (Inc.) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq février 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Armand Bouffard, Antonio Trahan, hôteliers, et Lucien Ouellet, comptable, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: L'objet de cette Association sera d'unir tous les hôteliers de la région du Nord-Ouest Québécois, afin de protéger leurs droits, sctis le nom de \"L'Association des Hôteliers Licenciés du Nord-Ouest Québécois (Inc.)\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le cinq février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Le Système Comptant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du.trois février 1951, constituant en corporation: David Goodman, Jack Lighstone, avocats, et Imelda Langlois, employée, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Pour faire le commerce de produits alimentaires de toute nature et espèce, sous le nom de \"Le Système ^Comptant Inc.\", avec un capital de $500,000.divisé en 3,000 action ordinaires d'une valeur nominale de $50 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victo-riaville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le trois février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSDLETS.Lidamar Construction & Realty Co., Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf janvier 1951, constituant en corporation: David Felberg, Dame Lily Rapp, épouse séparée de biens de David Felberg, Dame Lottie Dubs, veuve du feu David Rapp, tous marchands publics, des cité et district judiciaires de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'amélioration et de construction d'immeubles, sous le nom de stock of $150,000, divided into 7,500 common shares of $10 each, and 7,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Bernard Boulevard, Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.L'Association des Hôteliers Licenciés du Nord-Ouest Québécois (Inc.) Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of February, 1951, to incorporate as a corporation without shares capital: Armand Bouffard, Antonio Trahan, hotel keepers, and Lucien Ouellet, accountant, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: The object of this Association is to unite all the hotel keepers of the district northwest of Quebec, so as to protect their rights, under the name of \"L'Association des Hôteliers Licenciés du Nord-Ouest Québécois (Inc.)\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Le Système Comptant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of February, 1951, incorporating: David Goodman, Jack Lighstone, advocates, and Imelda Langlois, employee, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in food products, of every kind and sort, under the name of \"Le Système Comptant Inc.\", with a capital stock of $500,000, divided into 3,000 common shares of a nominal value of $50 each and 3,500 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this third day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Lidamar Construction & Realty Co., Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of January, 1951, incorporating: David Felberg, Dame Lily Rapp, wife separate as to property of David Felberg, Dame Lottie Dubs, widow of the late David Rapp, all public merchants, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on a general real estate improvement and constructing business, under the name of 994 GAZETTE OFFICIELLE DE QLÉBEC, Québec, 2A mars 1951, Tome 83, N° 12 \"Lidamar Construction & Realty Co., Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.\"Lidamar Construction & Realty Co., Inc.\", with a capital stock of $100,000.divided into 250 common shares of $100.each, and 750 preferred shares of $100.each.The head -office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Maison Du Bon Ton Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du cinq février 1951, constituant en corporation: June Kirlin, Mavis Grant et Sylvia Rabinovich, secrétaires, filles majeures, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le négoce ou le commerce de vêtements de toute nature et description pour femmes, sous le nom de \"Maison du Bon Ton Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Marché St Pierre Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec dès lettres patentes, en date du huit février 1951, constituant en corporation: Gérard Bernier, boucher, Raymond-M.Pelletier, voyageur de commerce, et Dame Pauline L.Pelletier, épouse contractuellement séparée de biens de Raymond-M.Pelletier, tous de Jonquière, district, judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épicerie-boucherie, sous le nom de \"Marché St-Pierre Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o ' L.DÉSILETS.May fair Glass Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conforniément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du trente janvier 1951, constituant en corporation: Joseph S.Caplan, Harold Lande, Murray Lapin et Alan Gold, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de verre, porcelaine, faience, objets en terre cuite, céramique et produits en bois et en métal contenant Maison Du Bon Ton Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifth day of February, 1951, incorporating: June Kirlin, Mavis Grant and Sylvia Rabinovich, secretaries, spinsters, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purpose's: To manufacture and deal in or with women's apparel of every nature and description, under the name of \"Maison du Bon Ton Lie\", with a capital *stock of $40,000.divided into 200 preferred shares having a par value of $100.each, and 200 common shares having a par value of $100 each; The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o \" Deputy Attorney General.Marché St Pierre Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Gérard Bernier, butcher, Raymond M.Pelletier, commercial traveller, and Dame Pauline M.Pelletier, wife separate as to property by marriage contract of Raymond M.Pelletier, all of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on business as grocers, butchers, under the name of \"Marché St-Pierre^Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, ~, 29709 Deputy Attorney General.Mayfair Glass Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirtieth day of January; 1951, incorporating: Joseph S.Caplan, Harold Lande, Murray Lapin and Alan Gold, all advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in glass, porcelain, china, earthenware, ceramics and wood and metal products containingTany of these mate- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1951, Vol 83, No.lê 995 aucune de ces matières, sous le nom de \"Mayfair Glass Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacun et en 6,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente janvier 1951.L'Assistant-procureur général, .29709 L.DÉSILETS.rials, under the name of \"Mayfair Glass Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 2,000 common shares having a par value of $5.each, and 6,000 preferred shares having a par value of $5.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Mazelle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-GouverneuJ de la pro: vince de Québeé, des lettres patentes en date du huit février 1951, constituant en corporation: Louis Stallman, marchand, Emmanuel Cooke, avocat et Lucy V.Clarke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements en détail, sous le nom de \"Mazelle Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1123 est, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Mazelle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Louis Stallman, merchant, Emmanuel Cooke, advocate, and Lucy V.Clarke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business, retail, of wearing apparel, under the name of \"Mazelle Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1123 St.Catherine East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o* Deputy Attorney General.Modern Tire Limited Modern Tire Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the provin- vince de Québec des lettres patentes, en date du ce of Quebec, bearing date the third day of Fe- trois février 1951, constituant en corporation: bruary, 1951, incorporating: Alfred Coulombe, Alfred Coulombe, distributeur d'huile et de pé- distributor of oil and petroleum products, of Jon- trole, de Jonquière, district judiciaire de Chicou- quière, judicial district of Chicoutimi, Jacques timi, Jacques Angers, commerçant, de la cité de Angers, dealer, of the city of Quebec, and Paul Québec, et Paul Dussault, comptable, de Sillery, Dussault, accountant, of Sillery, both of the judi- tous deux du district judiciaire de Québec, pour cial district of Quebec, for the following purposes: les objets suivants: Exercer le commerce manufacturier, fabricant, To carry on the business of manufacturer and négociant d'accessoires, de pneus, de pièces de maker of and dealer in accessories, tires, machine machines et d'outils, et généralement de tous parts and tools, and in general all articles con- autres articles se rapportant au commerce, à Fin- nected with the automobile and bicycle business, dustrie et au négoce de l'automobile et du bicycle, industry and trade, under the name of \"Modern sous le nom de \"Modern Tire Limited\", avec un Tire Limited\", with a capital stock of $20,000 capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 divided into 200 shares of $100 each, chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, The head office of the company will be at Jon-district judiciaire de Chicoutimi.quière, judicial district of Chicoutimi.Daté dû bureau du Procureur général le trois Dated at the office of the Attorney General, février 1951.this third day of February, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DESDLETS, 29709-o L.DÉSILETS.29709 Deputy Attorney General.Norgate Florist Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit février 1951, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, et Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: En général, exercer le commerce comme fleuristes, pépiniéristes, jardiniers maraîchers, pro- * Norgate Florist Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, secretary, both of the City of Montreal, and Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: Generally to carry on the business of florists, nurserymen, market garderners, fruit growers 996 GAZETTE OFFICIELLE DE QLÉBEC, Québec, SA mars 1951, Tome 83, N° 1S ducteurs de fruits et marchands de graines dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Norgate Florist Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la.compagnie sera à 1151 Boulevard Décarie, cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Oeuvre des Terrains de Jeux de Cap St.Ignace O.T.J.Cap St.Ignace Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier février 1951,constituant en corporation sans capital-actions: L.Ernest Méthot, industrial, Jos-Alphonse Fortin, secrétaire-trésorier, Ls.-Jacques Bcrnier, cultivateur, Réal Bélanger, barbier, Alph-Adrien Bernier, commis, et Benoit Scherrer, agent d'assurances, tous de Cap St-Ignace, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants D'organiser les loisirs extérieurs, sous le nom de \"Oeuvres des Terrains de Jeux de Cap St.Ignace\" \u2014 \"O.T.J.Cap St.Ignace\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Cap St-Ignace, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général le premier février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.and seedmcn in all its branches, under the name of \"Norgate Florist Inc.\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100.each.The head office of the Company will be at 1151 Decarie Blvd.City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Oeuvre des Terrains de Jeux de Cap St.Ignace O.T.J.Cap St.Ignace Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of February, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: L.Ernest Méthot, industrialist, Jos Alphonse Fortin, secretary-treasurer, Ls.Jacques Bernier, farmer, Real Bélanger, barber, Alph Adrien Bernier, clerk, and Benoit Scherrer, insurance agent, all of Cap St-Ignace, judicial district of Montmagny, for the following purposes: To organize outdoor sports and playgrounds, under the name of \"œuvre des Terrains de Jeux de Cap St.Ignace\" \u2014 \"O.T.J.Cap St.Ignace\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited is $50,000.The head office of the corporation will be at Cap St-Ignace, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this first day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Paul Constantineau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit février 1951, constituant en corporation: Paul Constantineau, de Château-Richer, Pierre Gosselin, de Boischatel, Paul Eusèbe Belleau, Joseph Cyprient Hudon, Joseph Ga-laise et Gérard Larochelle, tous quatre de la cité de Québec et tous ajusteurs, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme ajusteurs d'assurances, répartiteurs d'avaries, estimateurs, inspecteurs, enquêteurs, courtiers et agents dans toutes leurs différentes spécialités, sujettes au consentement préalable du Surintendant des assurances de la province de Québec, sous le nom de 'Taul Constantineau Inc.\", avec un capitol de $35,000 divisé en 350 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.* Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Paul Constantineau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Paul Constantineau, of Château Richer, Pierre Gosselin, of Boischatel, Paul-Eusèbe Belleau, Jo-seph-Cyprien Hudon, Joseph G alaise and Gérard Larochelle, all four of the City of Quebec, and all adjusters, in the Judicial District of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of insurance adjusters, average adjusters, appraisers, inpectors investigators, brokers, and agents in all their various branches subject to the previous consent of the Superintendent of Insurance of the Province of Quebec, under the name of \"Paul Constantineau Inc.\", with a capitol stock of $35,000.divided into 350 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Quebec, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Pomponnette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois février 1951, constituant en corpora- Pomponnette Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of February, 1951, incorporating Josaphat Bras- QLEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1951, Vol.83, No.12 997 tion: Josaphat Brassard, bijoutier, J.-Émile Maheu, comptable agréé, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, et Ronald Hal-pin, avocat, de Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Fabriquer, exploiter l'industrie et faire le commerce sous toutes les formes de bijouterie, orfèvrerie et horlogerie, parfumerie, valises, sous le nom de \"Pomponnette Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 256, Ste-Catherine, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trois février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS, Quebec Chinchilla Ranch Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 176, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze février 1951, constituant en corporation: Thérèse Bernier Côté, ménagère, épouse séparée de biens de J.-C.Côté, de Roscmont, district judiciaire de Montréal, Jos-Albert-Roméo Cardinal, commerçant, d'Oka, Terrebonne, et Albert Triquet, sténographe, épouse séparée judiciairement de corps et de biens de Paul Triquet, Lt.Col., de la cité de Québec, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire l'élevage et le commerce des animaux à fourrure en généra), et plus particulièrement des chinchillas, sous le nom de \"Quebec Chinchilla Ranch Company\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Salon Astrid Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un janvier 1951, constituant en corporation: George Wanklyn Hall, avocat, de la cité de Montréal, John Anthony Nolan, et Pierre de Grandpré, avocats, tous deux de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Tenir et opérer des salons de beauté et exercer tout commerce connexe et accessoire à ce genre d'entreprise, sous le nom de \"Salon Astrid Limitée\", avec un capital de $99,000 divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 790 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Sterling Craft Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été sard, jeweller, J.Emile Maheu, chartered accountant, both of the city and judicial district of Montreal, and Ronald Halpin, advocate, of Saint-Eustache, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To manufacture, carry on business and deal in jewellery, goldware and clocks and watches, perfumes, trunks, under all forms thereof, under the name of \"Pomponnette Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at 256 St.Catherine Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Quebec Chinchilla Ranch Company Notice, is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of February, 1951, incorporating: Thérèse Bernier Côté, wife separate as to property of J.C.Côté, of Roscmonut, judicial district of Montreal, Jos Albert Roméo Cardinal, dealer, of Oka, judicial district of Terrebonne, and Alberte Triquet, stenographer, wife lawfully separate as to bed and board of Paul Triquet, Ltd.Col., of the city of Quebec, judicial district of Québec, for the following purposes: To carry on the business of breeding and raising fur bearing animals in general and more particularly chinchilla under the name of \"Quebec Chinchilla Ranch Company\", with a capital stock of S40.000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Salon Astrid Limitée Notice is hereby given that under Part-I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1951, incorporating: George Wanklyn Hall, advocate, of the city of Montreal, John Anthony Nolan, and Pierre de Granpré, advocates, both of the city of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate and maintain beauty parlours and carry on any business incidental to or connected therewith .under the name of \"Salon Astrid Limitée\", with a capital stock of 899,000 divided into 200 common shares of S100 each and 790 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first dav of January, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Sterling Craft Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been 998 GAZETTE OFFICIELLE DE QVÉBEC, Québec, 2L mars 1961, Tome 83, N° 12 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-neuf janvier 1951, constituant en corporation: Geoffroy Birtz, avocat, Madeleine Béique, avocat, fille majeure et Gabrielle Lahaie, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer comme bijoutiers et graveurs, marchands de diamants, sertisseurs de pierres, fabricants de montres et horloges, orfèvres, travailleurs en argent et en cuivre, sous le nom de \"Sterling Craft Ltd.\", avec un captai de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à VVater-ville, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier .1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÊSIXETS.Stoney's Car Market (Montreal) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit février 1951, constituant en corporation: Charles Wolfson, avocat, Alva Phyllis Boyd, sténographe, tous deux de la cité de Montréal et Aaron Hyman Mettarlin, notaire, de la cité d'Ou-tremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général de toutes sortes d'automobiles, moteurs, engins, machines et tous accessoires et pièces y connexes, sous le nom de \"Stoney's Car Market (Montreal) Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté.du bureau du Procureur général, le huit février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, represented by Mr Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-ninth day of January, 1951, incorporating: Geoffroy Birtz, lawyer, Madeleine Béique, lawyer, spinster, and Gabrielle Lahaie, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing jewellers and engravers, diamond merchants, stone setters, watch and clock makers, goldsmiths, silver-smiths, copper-smiths,- under the name of \"Sterling Craft Ltd.\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Wa-terville, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of January, 1951.L.DÉSDLETS, 29709-o Deputy Attorney General.Stoney's Car Market (Montreal) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1951, incorporating: Charles Wolfson, advocate, Alva Phyllis Boyd, stenographer, both of the city of Montreal, and Aaron Hyman Mettarlin, notary, of the city of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in all kinds of automobiles, motors, engines, machines and all accessories and parts thereto .under the name of \"Stoney's Car Market (Montreal) Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1951.\" L.DÉSILETS, 29709-o Deputy Attorney General.Voyages Claude Michel, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1951, constituant en corporation: Claude Michel, agent Taschereau Fortier, avocat, tous deux des cité et district judiciaire de Québec, et Yves-R.Jamin, agent, de New-York, État de New-York, U.S.A., pour les objets suivants: Généralement exercer le commerce d'agence de voyages et de transport de personnes, effets ou marchandises, sous le nom de \"Voyages Claude Michel, Inc.\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le neuf février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Voyages Claude Michel, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1951, incorporating: Claude Michel, agent, Taschereau Fortier, advocate, both of the city and judicial district of Quebec, and Yves R.Jamin, agent, of New York, State of New York, U.S.A., for the following purposes: To carry on in general business of a travel agency and that of transportation of passengers, wares or merchandise, under the name of \"Voyages Claude.Michel, Inc.\", with a capital stock of $30,000 divided into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General., Warehousing Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Warehousing Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governqr of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1951, Vol.83, No.12 999 province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept janvier 1951, constituant en corporation: Roy Fraser Elliott, avocat, Amy Jean Fitzgerald, secrétaire, et Margot Mary Quinn, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercerlle commerce d'emmagasinage et d'entreposage frigorique, sous le nom de \"Warehousing Corporation;;, avec un capital de $201,-000 divisé en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 284 rue Duke, en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.\u2022 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1951.L'Assistant-procureur général, 29709 L.DÉSILETS.Wilfrid Poudrier Machine Works Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six février 1951, constituant en corporation: Wilfrid Poudrier, manufacturier, Jeanne Sweeney, comptable, et Robert Poudrier, dessinateur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre des bouilloires, engins, machineries, outils et toutes sortes d'articles en fer, cuivre, coppe, acier ou autres métaux, sous le nom de \"Wilfrid Poudrier Machine Works Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au numéro 1087, nie Plessis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six février 1951.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January, 1951, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, Amy Jean Fitzgerald, secretary, and Margot Mary Quinn, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry jm the business of warehousing and cold storage, under the name of \"Warehousing corporation\", with a capital stock of $201,000.divided into 2,000 preferred shares of the par value of $100 each, and 1,000 common shares of the par value of $1.each.The head office of the Company will be at 284 Duke Street, in the City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-seventh day of January, 1951.L.DESILETS 29709-o Deputy Attorney General.Wilfrid Poudrier Machine Works Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of February, 1951, incorporating: Wilfrid Poudrier, manufacturer, Jeanne Sweeney, accountant, and Robert Poudrier, draughtsman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy and sell boilers, engines, machinery, tools and all kinds of ironware, and articles in copper, brass, steel or other metals, under the name of \"Wilfrid Poudrier Machine Works Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at No.1087 Plessis street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of February, 1951.L.DÉSDLETS, 29709 Deputy Attorney General.W.Vézina & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du 10 février 1951, constituant en corporation: Wilfrid Vézina, Marcel Vézina, Fernand Vézina, Aimé Vézina, plombiers, Denise Coteur, secrétaire, et Alphonse Senay, notaire, ce dernier de Lon-gueuil, tous les précédents des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs-plombiers et faire le commerce d'articles de plomberie et accessoires, sous le nom de \"W.Vézina & Fils Ltée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix février *1©51.L'Assistant-procureur général, 29709-o L.DÉSILETS.Lettres patentes annulées Avis est donné que, par jugement rendu à Montréal, le 14e jour de février 1951, par l'honorable juge Edouard Tellier, l'un des juges de la W.Vézina & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beajing date the tenth day of February, 1951, incorporating: Wilfrid Vézina, Marcel Vézina, Fernand Vézina, Aimé Vézina, plumbers, Denise Coteur, secretary, and Alphonse Senay, notary, the latter of Longueuil, all the foregoing of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes : To act as plumbing contractors and deal in plumbing supplies and accessories, under the name of \"W.Vézina & Fils Ltée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 dollars each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29709 Deputy Attorney General.Letters Patent Annuled Notice is hereby given that ift virtue of a judgment rendered at Montreal on February 14, 1951, by Honourable Justice Edouard Tellier, 1000 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 mars 1951, Tome 83, N° 12 Cour supérieure dans et pour le district judiciaire de Montréal, l'annulation des lettres patentes du \"Club Social Bienvenue Inc.\", constitué en corporation par lettres' patentes émises sous le grand sceau de la province de Québec, le 9 avril 1938, en vertu de la Loi des compagnies de Québec, a été décrétée, et ce, conformément aux dispositions de l'article 231 de ladite loi.Daté du bureau du Procureur général le 16 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 29721-0 L.DÉSILETS.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Li.'uter.ant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"D\"' Concernant l'addition d'une partie contractante \u2014 décret relatif aux établissements commerciaux da::s la ville de Richmond, la municipalité de Melbourne et le territoire compris dans un rayon de trois (3) milles de leurs limites.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), L'Union des Commis des Cantons de l'Est Inc., a présenté au Ministre du Travail une iequête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante de deuxième part à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 2861 du 17 juillet 1946 et amendements, relatif aux établissements commerciaux dans la ville de Richmond, la municipalité de Melbourne et le territoire compris dans un rayon de trois (3) milles de leurs limites; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951 ; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son-approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que cette requête soit acceptée et que le nom de ladite Union soit ajouté dans ledit décret numéro 2861, comme partie de deuxième part.(Document \"D\" annexé à l'arrêté).A.MORISSET, 29734-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Frémit: Le Lieutenant-gouverneur-en-Conseil Section \"E\" Concernant l'addition d'une partie contractante \u2014 décret relatif aux établissement commerciaux dans la ville de Windsor et un rayon de trois (3) milles de ses limites.one of the judges of the Superior Court, in and for the judicial district of Montreal, the cancellation of the letters patent of \"Club Social Bienvenue Inc.\" incorporated by letters patent issued under the Great Seal of the Province of Quebec, on April 9th, 1938, pursuant to the* Quebec Companies' Act, has been enacted,' and such in conformity with the provisions of section 231 of the said Act.Dated at the office of the Attorney General, March 16,1951.* L.DÉSILETS, 29721 Deputy Attorney General.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 230 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"D\" Concerning the adding of a contracting party \u2014 decree relating to the commercial establishments in the town of Richmond, the municipality of Melbourne and the territory comprised in a .radius of three (3) miles from their limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), \"L'Union des Commis des Cantons de l'Est inc.\" has submitted to the Minister of Labour a request to be accepted as co-contracting party of the second part to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 2261 of July 17, 1946, as amended, relating to the commercial establishments in the town of Richmond, the municipality of Melbourne and the territory comprised in a radius of three (3) miles from their limits; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27, 1951; Whereas no objection has been made against its approval; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said request be accepted and that the name of the said union be added in the said decree, number 2861, as party of the second part.(Document \"D\" annexed to the Order).A.MORISSET, 29734-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 230 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"E\" Concerning the adding of a contracting party\u2014 decree relating to the commercial establishments in the town of Windsor and a radius of three (3) miles from its limits. QLEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1961, Vol 83, No.12 1Ô01 Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), l'Union des Commis des Cantons de l'Est Inc, a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante de première part à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 3516 du 21 septembre 1944 et amendements, relatif aux établissements commerciaux dans la ville de Windsor et un rayon de trois (3) milles de ses limites; Attendu que la dite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951 ; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que cette requête soit acceptée et que.le nom de ladite Union soit ajouté dans ledit décret, numéro 3516, comme partie de première part.(Document \"E\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 29734-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"F\" Concernant l'addition d'une partie contractante \u2014 décret relatif aux tanneries et corroieries dans la province.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), \"La Tannerie Laurentienne Inc.\" a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante à la convention collective de travail relative aux tanneries et corroieries dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 523 du 5 février 1940; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ladite requête soit acceptée et que le nom de cet établissement soit ajouté dans ledit décret, numéro 523, comme partie de deuxième part.(Document \"F\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 29734-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL \u2022 CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section *'Q\" Concernant une modification au décret relatif à l'industrie de la construction dans les comtés Whereas, pursuant to the provisions of the Cllective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments, \"L'Union des Commis des Cantons de l'Est inc.\" has submitted to the Minister of Labour a request to be accepted as co-contracting party of the first part to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 3516 of September 21, 1944, as amended, relating to the commercial establishments in the town of Windsor and a radius of three (3) miles from its limits; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27 1951; Whereas no objection has been made against its approval; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, That this request be accepted and that the name of the said union be added in the said decree, number 3516, as pa'rty of the first part.(Document \"E\" annexed to the Order) A.MORISSET, 29734-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCLL CHAMBER Number 230 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"F*> Concerning the adding of contracting party \u2014 decree relating to the tanners and curriers in the Province.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), \"La Tannerie Laurentienne inc.\" has submitted to the Minister of Labour a request to be accepted as co-contracting party to the collective labour agreement relating to the tanners and curriers in the province of Quebec, rendered obligatory by the decree number 523 of February 5, 1940; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27, 1951; Whereas no objection has been made against its approval; It is ordained, therefore, upon the recommendation of \u2022the Honourable the Minister m of Labour, That the said request be accepted and that the name of this establishment be added in the said decree, number 523, as party of the second part.(Document \"F\" annexed to the Order) A.MORISSET, 29734-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCLL CHAMBER Number 230 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"G\" Concerning an amendment to the decree relating to the construction industry in the coun- 1002 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A mars 1951, Tome 83, N° 12 de Maskinongé, St-Maurice, Laviolctte, Cham-plain et Trois-Rivières.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation d'une modification au décret numéro 1658 du 19 avril 1940 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans les comtés de Maskinongé, St-Maurice, Laviolette, Champlain et Trois-Rivières; »> Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1658, soit modifié comme suit : L'alinéa suivant est ajouté à l'article HI: \"D'accord avec les dispositions de l'alinéa précédent, les taux horaires minima établis pour tous les salariés de la zone I assujettis au décret, à l'exception des apprentis, sont augmentés de $0.05, à compter du 25 septembre 1950 inclusivement.\" (Document \"G\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 29734-o Greffier du Conseil Exécutif.AURÊTÊ EN CONSEIL .CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 230 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"C\" Concernant l'addition d'une partie contractante \u2014 décret relatif aux employés d'épiceries, de boucheries et de restaurants-épicieries dans la cité de Sherbrooke et un rayon de dix (10) milles de ses limites.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective -Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), l'Union des Commis des Cantons de l'Est Inc., a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante de deuxième part à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 2331 du 17 juin 1940 et amendements, relatif aux employés d'épiceries, de boucheries et de restaurants-épiceries dans la cité de Sherbrooke et un rayon de dix (10) milles de ses limites; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 janvier 1951; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que cette requête soit acceptée et que le nom de ladite union soit ajouté dans ledit décret, numéro 2331, comme partie de deuxième part.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 29734-0 Greffier du Conseil Exécutif.ties of Maskinongé, St.Maurice, Laviolette, Champlain and Three-Rivers.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of an amendment to the decree number 1658 of April 19, 1940, and amendments, relating to the construction industry in the counties of Maskinongé, St.Maurice, Laviolette, Champlain and Three Rivers; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27, 1951; Whereas no objection has been made against its approval: It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, » That the said decree, number 1658, be amended as follows: The following paragraph is added to section III: \"Pursuant to the provisions of the foregoing paragraph, the minimum hourly rates established for all employees of zone I governed by the decree, with the exception of apprentices, are increased by $0.05 as from September 25, 1950 inclusive.\" (Document \"G\" annexed to the Order) A.MORISSET, 29734-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER ' Number 230 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"C\" Concerning the adding of a contracting party decree relating to the grocery, butcher-shop and grocery-restaurant employees in the city of Sherbrooke and a radius of ten miles from its limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), \"L'Union des Commis des Cantons de l'Est Inc.\" has submitted to the Minister of Labour a request to be accepted as co-contracting party of the second part to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 2331 of June 17, 1940, and amendments, relating to the grocery, butcher-shop and restaurant-grocery employees in the city of Sherbrooke and a radius of ten (10) miles from its limits; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of January 27, 1951; Whereas no objection has been made against its approval; Ii is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, That this request be accepted and that the name of the said union be added in the said decree, number 2331, as party of the second part.(Document \"C\" annexed to the Order) A.MORISSET, 29734-o Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1951, Vol.83, No.12 1003 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 229 Québec, le 7 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-gouverneur-en-Conseil Section \"C\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés de Hull, Gatineau, Papineau, Pontiac, Labelle et Témiscamingue.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail : Que le décret numéro 1254 du 10 novembre 1949 et ses amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés de Hull, Gatineau, Papineau, Pontiac, Labelle et Témiscamingue, soit prolongé jusqu'au 12 novembre 1951.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) .A.MORISSET, 29734-0 Greffier du Conseil Exécutif.Assemblées The Canada & Gulf Terminal Railway Company Avis est donné qu'une assemblée générale et spéciale des actionnaires de la compagnie ci-dessus, sera tenue à Rimouski, 1 rue St-Jean, à 11 heures A.M.(heure avancée) le 28 mars 1951, pour les fins ordinaires d'une assemblée générale annuelle.Le Secrétaire, 29678-1 l-2-o P.-E.GAGNON.La Compagnie des Tramways de Montréal Assemblée générale annuelle Avis est par les présentes donné que, conformément aux règlements de la compagnie, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de \"La Compagnie des Tramways de Montréal\" sera tenue aux bureaux de la compagnie, Immeuble des Tramways, 159 ouest, rue Craig, Montréal, à midi, jeudi le 26 avril 1951.Cette assemblée est convoquée pour la réception du rapport annuel, l'élection du nouveau conseil, et la délibération de toute autre question du ressort de l'assemblée.Les registres de transfert seront fermés du 6 au 25 avril 1951 inclusivement.Montréal, le 16 mars 1951.Par ordre du conseil d'administration, Le Secrétaire-trésorier, 29728-12-3-o T.D.ROBERTSON.AVIS Avis est, par les présentes, donné que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie \"Quebec Central Railway Company\" sera tenue aux bureaux de la compagnie Canadian Pacific Railway Company, Montreal, Canada, mercredi le 18 avril 1951, à onze heures du matin, ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 229 Quebec, March 7, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"C\" Concerning an extension of the decree relating to the construction industry and trades in the counties of Hull, Gatineau, Papineau, Pontiac, Labelle and Témiscamingue.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, That the decree number 1254 of November 10, 1949, as amended, relating to the construction industry and trades in the counties of Hull, Gatineau, Papineau, Pontiac, Labelle and Témiscamingue, be extended until November 12, 1951.(Document \"C\" annexed to the Order) A.MORISSET, 29734-0 Clerk of the Executive Council.Meetings The Canada & Gulf Terminal Railway Company Notice is hereby given that a general and special meeting of the shareholders of the above Company will be held at Rimouski, 1 St-John Street, at 11 o'clock (daylight saving time) the 28th day of March 1951, for the usual purposes of a general annual meeting.P.-E.GAGNON, 29678-1 l-2-o Secretary.Montreal Tramways Company Annual General Meeting Notice is hereby given that in accordance with the By-laws of the company, the Annual General Meeting of the shareholders of \"Montreal Tramways Company\" will be held at the company's offices, Tramways Building, 159 Craig Street West, Montreal, P.Q., at 12 o'clock noon, on Thursday, the 26th day of April, 1951.This meeting will be held for the reception of the Annual Report, Election of Directors, and the transaction of such other business as may legally come before said meeting.The transfer books will be closed from the 6th day of April, 1951 to the 25th day of April, 1951, both days inclusive.Montreal, March 16th, 1951.By order of the Board, T.D.ROBERTSON, Secretary-Treasurer.NOTICE Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the shareholders of \"Quebec Central Railway Company\" will be held at the offices of the Canadian Pacific Railway Company, Montreal, Canada, on Wednesday, the 18th day of April, 1951, at the hour of eleven o'clock in the 1004 GAZETTE OFFICIELLE DE QLÉBEC, Québec, 2A mars 1951, Tome 83, N° 12 pour l'élection de deux directeurs représentant les obligataires et, en général, pour la transaction de toute autre affaire.- Les actionnaires enregistrés le 14 mars 1951 peuvent assister et voter à l'assemblée.Daté à Montréal, Canada, le 1er mars 1951.Le Secrétaire, 29729-12-3 C.NIDEROST, C.R.Avis divers avis de changement de la date de présentation des candidats et de la date des élections générales.Avis est, par les présentes, donné que la ville de Mackayville, en conformité de l'article 173 de la Loi des cités et villes, présentera au Lieutenant-gouverneur en conseil, une requête pour changer la date de la présentation des candidats et la date des élections générales.A une assemblée Spéciale des membres du Conseil municipal de la corporation de la ville de Mackayville, tenue le 27 février 1951, le soussigné, secrétaire-trésorier, a été requis de préparer les formalités nécessaires pour changer la date des élections comme suit: la* date de la présentation des candidats ainsi que celle des élections générales, qui sont actuellement fixées respectivement au 25 janvier ou au premier jour juridique suivant, et au premier jour juridique de mai, seront à l'avenir fixées respectivement au 26 avril, pour la présentation des candidats, et si ce jour est férié, au premier jour juridique suivant; et au 2 mai, pour lesélections^générales, et si ce jour est férié, au premier jour juridique suivant.La requête sera présentée après la publication des avis ordonnés par la loi.Mackayville, le 27e jour de février 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29613-10-4-o ROLAND BARBEAU.Avis est donné que, par procuration exécutée le 23 février 1951, W.H.Laidley de 2000, édifice Aldred, 507 Place d'Armes, Montréal, a été nommé agent principal dans la Province de Québec de la compagnie \"American Can Company,\" une compagnie dûment autorisée à exercer son commerce dans ladite Province, en lieu et place de Alan S.Bell de Montréal, dont la nomination a été révoquée, et que le bureau principal de ladite compagnie dans la Province est maintenant à l'adresse donnée ci-dessus.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 17 mars 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29710 JEAN BRUCHÉSI, Paré Builders' Mart Inc.Extrait du règlement N° XXH concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à quatre.\"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau composé de quatre directeurs lesquels seront élus pour un an par les actionnaires à l'assemblée générale annuelle.\" Vraie copie Lé Président, 29713-0 ROBERT-YVON PARÉ, forenoon, for the election of two directors representing the Security Holders and, for the transaction of business generally.Stockholders of record on the 14th day of March, 1951, may attend and vote.Dated at Montreal, Canada, this 1st day of March, 1951.C.NIDEROST, K.C., 29729-12-3-0 Secretary.Miscellaneous Notices Notice of change of Date of Nominations of Candidates and Date of General Elections.Notice is hereby given that the Town of Mackayville, in conformity with section 173 of the Cities and Towns' Act, will submit to the Lieutenant-Governor in Council, a petition to change the date of nominations of candidates and the date of General elections.At a special meeting of the members of the Municipal Council of the Corporation of the Town of Mackayville, held on the 27th of, February 1951, the undersigned, secretary-treasurer, was requested to prepare the formalities required to change the date for the elections as follows: the date for the nomination of candidates and also that of the general elections, actually fixed respectively to the 25th of January or first juridical day following, and to the first juridical day of May, shall for the future, be fixed respectively to the 26th of April, for the nomination of candidates and if this day be a holiday, to the first following juridical day; and to the 2nd of May for the general elections and if this day be a holiday, to the first juridical day following same.The petition will be presented after publication of the notices required by law.Mackayville, February 27th, 1951.ROLAND BARBEAU, 29613-10-4-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that, by power of attorney executed on February 23rd, 1951, W.H.Laidley' of 2000 Aldred Building, 507 Place d'Armes, Montreal, was appointed Chief Agent in the Province of Quebec of \"American Can Company,\" a company duly licensed to carry on business in said Province, in the place and stead of Alan S.Bell of Montreal, whose appointment as such has been thereby revoked, and that the principal office of the said Company in this Province is now at the above given address.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of March, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29710-o Under-Secretary of the Province.Paré Builders' Mart Inc.Excerpt from By-law No.XXJJ concerning the increase in the number of Directors from three to four.\"The affairs of the company will be managed by a Board composed of four Directors, who shall be elected for one year by the shareholders at the annual general meeting.\" True Copy.ROBERT YVON PARÉ.29713 President QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1951, Vol.88, No.IS 1005 AVIS DE BACHAT Municipalité de la paroisse de Grande-Baie (Comté de Chicoutimi) Émission de $44,000 à 3-3^%, portant la date du 1er mai 1946 et échéant en séries jusqu'au 1er mai 1966 (règlement N° 53).Avis public est par les présentes donné que la municipalité de la paroisse de Grande-Baie, comté de Chicoutimi, rachètera par anticipation, au pair, le 1er mai 1951, en vertu d'une clause de rachat insérée dans le règlement N° 53 et reproduite sur les obligations, les obligations des échéances suivantes: 1er mai 1963\u2014$2,700 1er mai 1964\u2014 2,700 1er mai 1965\u2014 2,800 1er mai 1966\u2014 2,900.Lesdites obligations deviendront dues et payables et elles seront payables et rachetées, principal et intérêt, à la date ci-dessus mentionnée, en monnaie légale du Canada, avec intérêt couru jusqu'au 1er mai 1951, sur présentation et r&misc d'icelles, avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 1er mai 1951 attachés, à toute succursale de la Banque Canadienne Nationale dans la province de Québec, au choix du porteur.Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er mai 1951.Donné à Grande-Baie, comté de Chicoutimi, ce 16 mars 1951.Vraie copie certifiée Le Secrétaire-trésorier, 29711-o FRANÇOIS BERGERON.NOTICE OF REDEMPTION Municipality of the Parish of Grande-Baie (County of Chicoutimi) Issue of $44,000 at 3-3^%, bearing date May 1, 1946, and maturing serially up to May 1,1966 (By-law No.53).Public notice is hereby given that the municipality of the parish of Grande-Baie, County of Chicoutimi, will redeem, by anticipation, at par, on May 1, 1951, pursuant to a clause of redemption, inserted in By-law No.53, and reproduced on the bonds, the bonds of the following maturities: May 1, 1963\u2014$2,700 May 1, 1964\u2014 2,700 May 1, 1965\u2014 2,800 May 1, 1966\u2014 2,900 Said bonds will become clue and payable, and they will be payable and redeemable, capital and interest,,on the date hereinunder mentioned, in legal Canadian currency, with interest due up to May 1, 1951, upon presentation and remittance thereof, with all the interest coupons maturing after May 1st, 1951, attached, at any branch of the Banque Canadienne Nationale, in the Province of Quebec, at the option of bearer.Said Bonds shall cease to bear interest from after May 1, 1951.Given at Grande-Baie, county of Chicoutimi, March 16, 1951.Certified true copy FRANÇOIS BERGERON, 29711 Secretary-Treasurer.Le Quotidien Limitée Règlement N° 82 Il est par les présentes décrété que le nombre des membres du conseil d'administration soit réduit de cinq à trois.Je, soussigné, secrétaire-trésorier de \"Le Quotidien Limitée\", déclare que le Règlement N° 32 a été régulièrement adopté par le conseil d'administration de la compagnie le 16 août 1950, qu'il a été approuvé le 21 novembre 1950 par les actionnaires réunis en assemblée générale spéciale, qu'à cette assemblée il était détenu ou représenté par les actionnaires présents au moins 95% des actions du capital-actions de la compagnie et que ce règlement a été voté à l'unanimité.Lévis, ce 23ième jour de novembre, mil neuf cent cinquante.Le Secrétaire-trésorier, 29712-o MARCEL SIMARD.Le Quotidien Limitée By-Law No.82 It is hereby enacted that the number of members of the Board of Directors be reduced from five to three.I, the undersigned, secretary-treasurer of \"Le Quotidien Limitée\" declare that By-law No.32 was regularly adopted by the Board of Directors of the company, on August 16, 1950, and was approved on November 21, 1950, by the shareholders assembled at a special general meeting, that, at such meeting, at least 95% of the shares of the capital stock of the company were held or represented by the shareholders present, and that said By-law was unanimously voted.Levis, this 23rd day of November, nineteen hundred and fifty.MARCEL SIMARD, 29712 Secretary-Treasurer.Quebec Culvert Corporation Limited AVIS Avis est par les présentes donné qu'un règlement autorisant la distribution de l'actif de la compagnie entre ses actionnaires et la demande d'abandon de sa charte a été dûment adopté à une assemblée des directeurs tenue à 8ème.jour de mars 1951, et approuvé par les actionnaires à une assemblée générale spéciale des dits actionnaires tenue le 8ème jour de mars 1951.St-Hyacinthe, ce 17 mars 1951.Quebec Culvert Corporation Limited, Le Procureur, 29714-0 PH.POTHIER, C.R.Quebec Culvert Corporation Limited NOTICE Notice is hereby given that a By-law authorizing the distribution of the assets of the Company among its shareholders and application for surrender of the Company's Charter was duly enacted at a meeting of Directors held on the 8th day of March 1951, and approved by the shareholders at a special general meeting of the shareholders held on the 8th day of March 1951.St.Hyacinthe, March 17,1951.Quebec Culvert Corporation Limited, PH.POTHIER, K.C., 29714-0 Attorney. 1006 GAZETTE OFFICIELLE DE QlÉBEC, Québec, 24 mars 1951, Tome 88, N° 12 The Empire Shirt Manufacturing Company Limited Règlement \"A\" (1961) \"Il est par les présentes décrété comme règlement de \"The Empire Shirt Manufacturing Company Limited\" (ci-après appelée \"la compagnie\") comme suit: 1° Le nombre des directeurs de la compagnie est réduit de cinq à trois; 2° Le quorum aux assemblées du bureau de direction est réduit de trois à deux; 3° Les Règlements Généraux de la compagnie sont, amendés en conséquence.\" Copie certifié véritable.Le Secrétaire-trésorier, 29715-0 J.-ALEXANDRE BÉLAND.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicats de l'U.C.C.de Sacré-Cœur de Marie, Mégantic\", pour l'étude, la defense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 16 mars 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sacre-Cœur de Marie, comté de Mégantic.Le Sous-secrétaire de la Province, 29716-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association des Marchands Colporteurs de la Province de Québec,\" pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 21 février 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la Province, 29723-0 JEAN BRUCHÉSI.The Empire Shirt Manufacturing Company Limited By-law \"A\" (1961) \"It is hereby enacted as a By-law of \"The Empire Shirt Manufacturing Company Limited\" (hereinafter called \"The Company\") as follows: 1.The number of the Directors of the Company is reduced-from five to three; 2.The quorum at the meetings of the Board of Directors is reduced from three to two; 3.The General By-laws of the Company are amended to accord with the foregoing;\" Certified true copy.J.-ALEXANDRE BÉLAND, 29715-0 Secretary-Treasurer.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Sacré-Cœur de Marie, Mégantic\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary, on March 16, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sacré-Cœur de Marie, County of Mégantic.JEAN BRUCHÉSI, 29716 Under Secretary of theTrovince, NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association des Marchands-Colporteurs de la Province de Québec\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on February 21, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Quebec, judicial district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 29723 Under Secretary of the Province.C.& D.Beverages Inc.Règlement N° 5 \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de cette compagnie ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à quatre, de manière à ce que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de quatre directeurs.2.Tous les règlements, résolutions et procédures de la compagnie incompatibles à iceux sont, par les présentes, amendés et revisés afin de donner effet à ce règlement.Décrété le 6 février 1951.Témoin: Le sceau corporatif de la compagnie.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 29725 ANDREW B.VITA., C.& B.Beverages Inc.By-law No.5 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of this company, as follows : 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three to four, so that the Board of Directors of the company shall hereafter be composed of four directors.2.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended and revised in order to give effect to this by-law.\" Enacted this 6th day of February 1951.Witness: The corporate seal of the company, ANDREW B.VITA, 29725-0 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March SÀtk, 1951, Vol.83, No.12 1007 Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 20 février 1951, le règlement numéro 4, tel qu'amendé le 12 octobre 1950, et les règlements numéros 5 et 6 du \"Cercle Universitaire Laval\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 8 mars 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29724-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est donné que la compagnie \"Emerald Glacier Mines Limited\", (Libre de responsabilité personnelle) a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec ses actions, titres, certificats-actions, debentures et autres valeurs.Le siège social dans la Province est au N° 360 ouest, rue St-Jacques, suite 1216, Montréal: Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans toute procédure prise contre elle, est Gustave H.Rainville, des cité et district de Montréal, et dont l'adresse est 360 ouest, rue St-Jacques, suite 1216.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 20 mars 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 29736 JEAN BRUCHÉSI.Société Immeubles et développement Ltée Extrait des délibérations d'une Assemblée régulière ajournée des Directeurs de \"Société Immeubles et Développements Ltée\" tenue en la Cité de Hull, le 28 décembre, 1950, à 10.heures p.m.\"Sur motion dûment secondée il est résolu que: Le règlements présentement en viguçur, numéro 30, de la Compagnie, tel qu'adopté à une assemblée des Incorporateurs, tenue en la Cité de Hull, le 27 décembre 1950, à 3 heures p.m., et ratifié conformément à la Loi, à une assemblée des Actionnaires tenue à Hull, le 28 décembre 1950, à 3.35 heures p.m., soit changé et remplacé, de façon à ce que le nombre des Directeurs de la dite Compagnie soit réduit de cinq Directeurs à trois Directeurs.\" Certifié extrait conforme.Le Secrétaire-trésorier, 29741-o AIMÉ GUERTIN.Chartes \u2014 Abandon de Dominion Logging & Contracting Company Limited Avis de demande d'abandon de charte Avis est donné que \"Dominion Logging & Contracting Company Limited,\" constituée en corporation en vertu des dispositions de la Loi des Compagnies de Québec, S.R.1925, par Lettres Patentes en date du 14 mai 1930, ayant son siège social à St-Jean Deschaillons, dans le comté de Lotbinière, province de Québec, demandera incessamment l'abandon de sa charte conformément aux dispositions de la dite Loi des Compagnies de Québec, S.R.1925.Dominion Logging & Contracting Company, Limited, 29717-Q Par: EDMOND BOUCHARD.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the by-law No.4, as amended on the 12th day of October, 1950, and by-laws Nos.5 and 6 of the \"Cercle Universitaire Laval\", were approved by the Honourable the Provincial Secretary on the 20th day of February, 1951, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary, this eighth day of March, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29724 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that \"Emerald Glacier Mines Limited\" (No Personal Liability) has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The head office in the Province is at No.360 St.James Street West, Montreal, Suite 1216.Its chief agent foi the purpose of receiving service in proceedings against it is Gustave H.Rainville, of the city and district of Montreal, and whose address is 360 St.James Street West, Suite 1216.Given at the office of the Provincial Secretary, the 20th day of March, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 29736-0 Under Secretary of the Province.Société Immeubles et Développements Ltée Excerpt from the deliberations of an adjourned regular meeting of the Directors of \"Société Immeubles et Développements Ltée\", held in the City of Hull, on December 28, 1950, at 10 o'clock P.M.\"Upon motion duly seconded, it is resolved that: The By-law actually in force, number 30, of the company, as adopted at a meeting of the incorporators, held in the city of Hull, on December 27, 1950, at 3 o'clock P.M.and ratified according to law, at a meeting of the shareholders held at Hull, on December 28, 1950, at 3.35 P.M., be changed and replaced so that the number of Directors of the said company be reduced from five Directors to three Directors.\"- Certified True Copy.AIMÉ GUERTIN, 29741 Secretary-Treasurer.Charters \u2014 Surrender of Dominion Logging & Contracting Company Limited Notice of Application for Surrender of Charter Notice is given that \"Dominion Logging & Contracting Company Limited\" incorporated under the Quebec Companies' Act, R.S.1925, by letters patent dated May 14, 1930, having its head office at St.Jean Deschaillons, in the county of Lotbinière, Province of Quebec, will immediately apply for leave to surrender its charter, pursuant to the provisions of the said Quebec Companies' Act, R.S.1925.Dominion Logging & Contracting Company Limited, 29717 per: EDMOND BOUCHARD. 1008 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A mars 1951, Tome 83, N° 12 Avis est ,par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, R.S.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Caria Jane Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 décembre 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mars 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce seize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 29718 L.DESILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941 et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il aplu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"George Klein Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du onze septembre 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mars 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce seize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 29718 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Joliet Museum Handicraft Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du dix janvier 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mars 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce seize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 29718 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, revised Statutes of Quebec, chapter 276 .section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Carla Jane Inc.\" incorporated by letters patent dated the 28th day of December, 1945.Notice is also given that from and after the fifteenth day of March, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of March, 1951.L.DÉSILETS, 29718-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"George Klein Inc.\" incorporated by letters patent dated the eleventh day of September, 1946.Notice is also given that from and after the fifteenth day of March, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 29718-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Joliet Museum Handicraft Limited\" incorporated by letters patent dated the tenth day of January, 1949.Notice is also given that from and after the fifteenth day of March, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 29718-0 Deputy Attorney General.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de là Loi des compagnies de Québec, the Quebec Companies Act, section 26, chapter Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability article 26, et sujet à la responsabilité décrétée enacted by section 27 of the said Act, the Attorney par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur General, has been pleased to accept the surrender général d'accepter l'abandon de la charte de la of the charter of the company\" La Filature de compagnie \"La Filature de St-Georges Ltée \u2014 St.St-Georges Ltée \u2014 St.George Spinning Ltd.\" George Spinning Ltd.\", constituée en corpora- incorporated by letters patent dated the 1st day tion par lettres patentes en date du 1er décembre of December, 1948.1948.Avis est de plus donné qu'à compter du Notice is also hereby given that from and after quinze mars 1951, ladite compagnie a été dissoute, the fifteenth day of March, 1951, the said company has been dissolved.Daté du bureau du Procureur général, le 16 Dated at the office of the Attorney General, mars 1951.this sixteenth day of March, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSDLETS, 29718-0 L.DÉSILETS.29718 Deputy Attorney General.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, Sta- the Quebec Companies Act, section 26, chapter tuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability article 26, et sujet à la responsabilité décrétée enacted by section 27 of the said Act, the Attorney par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur General, has been pleased to accept the surrender général d'accepter l'abandon de la charte de la of the charter of the company \"L'Imprimerie compagnie \"L'Imprimerie Métropole, Incorpo- Métropole, Incorporée \u2014 Métropole Printing QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Llh, 1951, Vol.83, No.12 1009 rée \u2014 Métropole Printing Incorporated\", cons- Incorporated\" incorporated by letters patent tituée en corporation par lettres patentes en dated the 25th day of April, 1945.date du 25 avril 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze Notice is also hereby given that from and after mars 1951, ladite compagnie a été dissoute.the fifteenth day of March, 1951, the said company has been dissolved.Daté du bureau du Procureur general, le 16 Dated at the office of the Attorney General, mars 1951.this sixteenth day of March, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSIXETS, 29718-o L.DÉSILETS.29718 Deputy Attorney General.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu Notice is hereby given that under Part I of the de la première partie de la Loi des compagnies Quebec Companies Act, Revised Statutes of de Québec, article 26, chapitre 276, R.S.Q., Quebec, chapter 276, section 26, and subject to 1941, et sujet à la responsabilité décrété par the liability enacted by section 27 of the said l'articje 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur Act, the Attorney General has been pleased to général d'accepter l'abandon de la charte de la accept the surrender of the.charter of the com-compagnie \"R.F.Bovey (Québec) Ltd.\", cons- pany \"R.F.Bovey (Québec) Ltd., incorporated tituée en corporation par lettres patentes en date by letters patent dated the 29th day of January, du 29 Janvier 1947.1947.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze Notice is also given that from and after the mars 1951, ladite compagnie a été dissoute.fifteenth day of March, 1951, the said Company has been dissolved.Daté du bureau du Procureur général, ce seize Dated at the office of the Attorney General mars 1951.the 16th day of March, 1951.L'Assistant-procureur \"énéral, L.DÉSILETS, 29718 L.DESILETS.29718-o Deputy Attorney General.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"St.Johns Industries Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes, en date du 7 janvier 1942.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mars 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce seize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 29718 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"St.Johns Industries Company Limited\", incorporated by letters patent dated the 7th day of January, 1942.Notice is also given that from and after the fifteenth day of March-, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the 16th day of March, 1951.L.DÉSILETS, 29718-o Deputy Attorney General.Département des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Le soussigné donne avis que, tel que domandé The undersigned, do give notice that, as re- par une résolution du 2 janvier 1951 du conseil quested by a resolution of January 2, 1951, of de la municipalité de St-Jean de Dieu, comté the Council of the municipality of St-Jean de de Rivière-du-Loup, et conformément aux dis- Dieu, county of Rivière-du-Loup, and pursuant positions de l'article 130 du Code municipal, il a to the provisions of article 130 of the Municipal décrété, en date du 16 mars 1951, que les publi- Code, he has enacted, under date of March 16, cations de tous les avis publics, règlements, 1951, that the publication of all public notices, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf By-laws, resolutions or oders of the said corpo- celles requises dans la Gazette officielle de Québec, ration, save those required in the Quebec Official se fassent, à l'avenir, dans la langue française Gazette, be made, in future in the French lan- seulement.guage only.Le présent avis est publie en conformité de The present notice is published in conformity l'article 131 du Code municpal.(10 George with article 131 of the Municipal Code (10 VI, chapitre 55, section 2).George VI, chapter 55, section 2).Québec, le 16 mars 1951.Quebec, March 16, 1951.Le Ministre des Affaires Municipales,.BONA DUSSAULT, 29719-o BONA DUSSAULT.29719 Minister of Municipal Affairs.Département de PAgriculture Department of Agriculture Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la municipalité canton de Maria, comté de Bonaventure, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Notice is hereby given that the Farmers' Club of the municipality of the township of Maria, county of Bonaventure, having neglected for two years to comply with the requirements 1010 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SA mars 1951, Tome 88, N° 1S Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap, of the Farmers' Clubs, Act (R.S.Q.1941, chapter 118), le ministre de l'Agriculture le déclare 118) the Minister of Agriculture declares it dissous, conformément aux dispositions de l'ar- dissolved, pursuant to the provisions of section tide 44 de ladite Loi.44 of the said Act.Québec, ce 13 mars 1951.Quebec, March 13, 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, R.TRÉPANIER, 29720-o R.TRÉPANIER.29720 Deputy Minister of Agriculture.Avis est, par les présentes, donné que le cercle Notice is hereby given that the Farmers' agricole de la municipalité partie ouest du can- Club of the municipality west part of the town-ton Chester et le cercle agricole de la paroisse ship of Chester, and the Farmers' Club of the St-Norbert d'Arthabaska, tous deux dans le parish of St-Norbert, d'Arthabaska, both in the comté d'Arthabaska, ayant négligé, pendant county of Arthabaska, having neglected for two deux ans, de se conformer aux exigences de la years to comply with the requirements of the Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.Farmers' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118) 118), le ministre de l'Agriculture les déclare dis- the Minister of Agriculture declares them dissous, conformément aux dispositions de l'article solved, pursuant to the provisions of section 44 44 de ladite Loi.of the said Act.Québec, ce 13 mars 1951.Quebec, March 13, 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, \u2022 R.TRÉPANIER, 29720-o R.TRÉPANIER.29720 Deputy Minister of Agriculture.Avis est, par les présentes, donné que le cercle Notice is hereby given that the Farmer's Club agricole de la municipalité du canton Otis, le of the municipality of township Otis, the Farm-cercle agricole de la paroisse de St-François ers' Club of the parish of St-François d'Assise, d'Assise, le cercle agricole de la paroisse St- the Farmer's Club of the parish of St-Fulgence, Fulgence, le cercle agricole de la paroisse de St- the Farmer's Club of the parish of St-Gabriel de Gabriel de Ferland et le cercle agricole de la Ferland, and the Farmer's Club of the parish of paroisse de St-Gérard-Majella-de-Larouche, tous St-Gérard-Majella-de-Larouche, all five in the cinq dans le comté de Chicoutimi, ayant né- county of Chicoutimi, having* neglected for gligé, pendant deux ans, de se conformer aux two years to comply with the requirements of exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.the Farmers' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture 118), the Minister of Agriculture declares them les déclare dissous, conformément aux disposi- dissolved, pursuant to the provisions of section tions de l'article 44 de ladite Loi.44 of the said Act.Québec, ce 13 mars 1951.Quebec, March 13, 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, R.TRÉPANIER, 29720-o R.TRÉPAND2R.29720 Deputy Minister of Agriculture.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la municipalité du canton de Hereford et le cercle agricole de la paroisse de St-Henri d'Hereford, tous deux dans le comté de Compton, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 13 mars 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 29720-o R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse de St-Canut, le cercle agricole de la paroisse de St-Colomban et le cercle agricole de la paroisse Ste-Monique, tous trois dans le comté de Deux-Montagnes, ayant , négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles, (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 13 mars 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 29720-o R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse de Ste-Aurélie, le cercle agricole de la paroisse Ste-Marguerite et le cercle agricole de la mission de St-Nazaire de Buck-land, tous trois dans le comté de Dorchester, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, ehap.118), le ministre de l'Agri- Notice is hereby given that the Farmers' Club of the.municipality of the township of Hereford, the Farmers' Club of the parish of St-Henri d'Hereford,- both in the county of Compton, having neglected for two years to comply with the quircmcnts of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, March 13, 1951.R.TRÉPANIER, 29720 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the parish of St-Canut, the Farmers' Club of the parish of St-Colomban, and the Farmers' Club of the parish of Ste-Monique, all three in the county of Two Mountains, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q 1941, chapter 118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, March 13, 1951.R.TRÊPAND3R, 29720 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the parish of Ste-Aurélie, the Farmers' Club of the parish of Ste-Marguerite, and the Farmers' Club of the mission of St-Nazaire de Buckland, all three in the county of Dorchester, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmer's Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118), the Minister of Agriculture QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 2Lth, 1951, Vol.83, No.12 1011 culture les déclare dissous, conformément aux declares them dissolved, pursuant to the provi- dispositions de l'article 44 de ladite Loi.sions of section 44 of the said Act.Québec, ce 13 mars 1951.Quebec, March 13, 1951.Le Sous-ministre de l'Agriculture, R.TRÉPANIER, 29720-o R.TRÉPANIER.29720 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Instruction publique N° 195-51.Québec, le 12 mars 1951.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Sainte-Félicité, dans le comté de Matane, les lots 215 à 221 inclusivement du rang I du canton de Cherbourg et 224 à 233 inclusivement du rang II (2) du même canton, pour les annexer à la municipalité scolaire de Grosses-Roches, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 29681-1 l-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 241-51.Québec, le 12 mars 1951.Demande est faîte d'annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de la Ville de Richmond, dans le comté de Richmond, le territoire de la municipalité scolaire du Village de Melbourne, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 29680-1 l-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1364-49.Québec, le 16 mars 1951.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 7 mars 1951, d'annexer à la municipalité scolaire de Chandler, dans le comté de Gaspé-Sud, le territoire de la municipalité scolaire de Ri-vière-Nord-de-Pabos, dans le-même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1951.Le Surintendant de l'Instruction publique, 29737-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1824-50.Québec, le 16 mars 1951.-Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 7 mars 1951, de changer le nom de la municipalité scolaire de la Paroisse de Laprairie, dans le comté de Laprairie, en celui de \"Notre-Dame-du-Sacré-Cœur\", même comfé.Le Surintendant de l'Instruction publique, > 29737-0 O.J.DÉSAULNLERS.N° 1916-50.Québec, le 16 mars 1951.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 7 mars 1951, de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Georges, dans le comté de Beauce, le territoire de la Ville de Saint-Georges-Est, telle qu'érigée par proclamation ¦ officielle en date du 7 avril 1948, publiée dans la Gazette officielle de Québec du 17 avril de la même année, aux pages 1171 et 1172, et d'ériger ce territoire en une municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"L'Assomption\" dans le comté de Beauce.'Cet arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1951.Le Surintendant de l'Instruction publique, 29737-0 O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.195-51.Quebec, March 12, 1951.Application is made to detach from the school municipality of Sainte-Félicité, in the county of Matane, lots 215 to 221 inclusively, of range I of the Townslup of Cherbourg and 224 to 233 inclusively of range II (2) of the same township to annex them to the school municipality of Grosses-Roches, in the same county.O.J.DÉSAULNLERS, 29681-11-2 Superintendent of Education.No.241-51.Quebec, March 12, 1951.Application is made to annex, for Catholic tax-payers only, to the school municipality of the town of Richmond, in the county of Richmond, the territory of the school municipality of the Village of Melbourne, in the same county.\u2022 O.J.DÉSAULNIERS, 29680-11-2 Superintendent of Education.No.1364-49.Quebec, March 16, 1951.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated the 7th day of March, 1951, to annex to the school municipality of Chandler, in the county of Gaspe-South, the territory of the school municipality of Rivière-Nord-de-Pabos, in the same county.The said order in council to become effective the 1st of July, 1951.\u2022 O.J.DÉSAULNIERS, 29737 Superintendent of Education.No.1824-50.Quebec, March 16, 1951.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated the 7th day of March, 1951, to change the\" name of the school municipality of the Parish of Laprairie, in the county of Laprairie, into that of \"Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 29737 Superintendent of Education.No.1916-50.Quebec, March 16, 1951.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated the 7th day of March, 1951, to detach from the school municipality of Saint-Georges, in the county of Beauce, the territory of the Town of Saint-Georges-East, as erected by official proclamation dated April 7,1948, published in the Quebec Official Gazette on April 17 of the same year, on pages 1171 and 1172, and to erect such territory into a separate school municipality, under the name of \"L'Assomption\", in the county of Beauce.The said order in council to become effective on the 1st of July, 1951.O.J.DÉSAULNIERS, 29737 Superintendent of Education. 1012 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2L mars 1951, Tome 88, N° 12 N° 42-50.Québec, le 17 mars 1951.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 7 mars 1951, d'annexer à la municipalité scolaire protestante de la Cité de Magog, dans le comté de Stanstead, pour les protestants seulement, le territoire décrit comme-suit, savoir: \"'Partant du coin sud-ouest du comté de Sherbrooke où il touche les comtés de Brome et Shefford, allant vers le nord le long de la ligne de démarcation entre les comtés de Shefford et - de Sherbrooke jusqu'au comté de Richmond; de là, vers l'est le long de la ligne entre les comtés de Richmond et Sherbrooke à la limité ouest de Saint-Denis de Brompton au milieu du lac Brompton; de là, suivant la ligne de démarcation qui se trouve entre les rangs XIV et XIH dans une direction sud à la ligne entre les lots 23 et 24 du rang XH; de là, vers l'est le long de la ligne entre les lots 23 et 24 des rangs XIII et XII à la limite ouest de la municipalité de Rock Forest; de là, vers le nord le long de la ligne entre les rangs XH et XI jusqu'au lot 21; de là, vers l'est à travers le rang XI sur la ligne entre les lots 22 et 21 ; de là, vers le nord le long de la ligne entre les rangs XI et X, jusqu'au lot 19; vers l'est à travers le rang X sur la ligne entre les lots 20 et 19; vers le nord le long de la ligne entre les rangs X et IX jusqu'au lot 18; dç là, vers l'est, à travers le rang IX sur la ligne entre les lots 19 et 18; de là, vers le sud le long de la ligne entre les rangs IX et VIII jusqu'au village de Danville; de là, vers l'est le long de la ligne de démarcation au chemin public lequel se trouve parallèle aux rails du chemin de fer du Pacifique Canadien; de là, vers le sud le long de'ce chemin au comté de Stanstead; de là, vers l'ouest le long de la ligne entre les comtés de Stanstead et Sherbrooke jusqu'à ce qu'il atteigne le comté de Brome, et continuant sur cette ligne vers l'ouest entre les comtés de Brome et de Sherbrooke jusqu'au point de départ, soit le coin sud-ouest du comté de Sherbrooke touchant au comté de Shefford.\" Le Surintendant de l'Instruction publique, 29737-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.42-50.Quebec, March 17, 1951.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated March 7, 1951, to annex to the Protestant School Municipality of the City of Magog, in the county of Stanstead, for Protestants only, the territory described as follows, to wit: \"Starting at the south-west corner of the County of Sherbrooke, where it touches the counties of Brome and Shefford, going north along the boundary line between Shefford and Sherbrooke counties to the County of Richmond; thence east along the line between the counties of Richmond and Sherbrooke to the western boundary of Saint-Denis de Brompton, in the middle of Brompton Lake; thence, following this boundary line, which is the line between Ranges XIV and XIII, in a southerly direction to the line between lots 23 and 24 in Range XII; thence east along the line betwe|n lots 23 and 24 in Ranges XIII and XII to the western boundary of the municipality of Rock Forest; thence north along the line between Ranges XII and XI to lot 21; thence east across Range XI on the line between lots 22 and 21; thence north along the line between Ranges XI and X to lot 19; easterly across Range X, on the line between lots 20 and 19; northerly along the line between Ranges X and IX to lot 18; thence easterly across Range IX on the line between lots 19 and 18; thence southerly along the line between Ranges IX and VIII to the Village of Dauville; thence easterly along its boundary line to the public highway which runs parallel to the Canadian Pacific Railway tracks; thence southerly along this highway to the County of Stanstead; thence westerly along the line between the counties of Stanstead and Sherbrooke until the County of Brome is reached and continuing on this line westerly, between the counties of Brome and Sherbrooke, to the point of starting, \u2014 the south-west corner of the county of Sherbrooke, touching Shefford County.\" O.J.DÉSAULNIERS, 29737 Superintendent of Education.N° 1824-50.No.1824-50.Québec, le 16 mars 1951.Quebec, March 16, 1951.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouver- His Honour the Lieutenant-Governor in neur en conseil, par arrêté ministériel en date Council has been pleased, by Order in Council du 7 mars 1951, de changer le nom de la muni- dated the 7th day of March, 1951, to change cipalité scolaire de la Paroisse-de-la-Nativité-de- the name of the school municipality of the Laprairie, dans le comté de Laprairie, en celui Paroisse-de-la-Nativité-de-Laprairie, in the coun- de \"Paroisse de Laprairie\", même comté.ty of Laprairie, into that of \"Paroisse de Laprairie\", same county.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.J.DÉSAULNIERS, 29737-0 O.J.DÉSAULNIERS.29737 Superintendent of Education.N° 1854-50.Québec, le 16 mars 1951.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 7 mars 1951, de détacher de la municipalité scolaire de Saint-David-de-l'Auberivière, dans le comté de Lévis, les lots Nos 370 et 371 du cadastre officiel de Saint-David-de-l'Auberivière, et de les annexer à la municipalité scolaire de Sorosto, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1951.Le Surintendant de l'Instruction publique, 29737-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.1854-50.Quebec, March 16, 1951.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated the 7th day of March, 1951, to detach from the school municipality of Saint-David-de-l'Auberivière, in the county of Levis, the lots Nos.370 and 371 of the official cadastre of Saint-David-de-1'Auberivière, and to annex them to the school municipality of Sorosto, in the same county.' The said order in council to become effective on the 1st of July 1951.O.J.DÉSAULNIERS, 29737 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 24th, 1951, Vol 83, No.12 1013 N° 224-51.Québec, le 19 mars 1951.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Templeton-Est, dans le comté de Papineau, la partie du lot N° 5, rang II (2) du canton de Templeton, appartenant à Monsieur Réal Beauchamp, et de l'annexer à la municipalité scolaire de Cousineau, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 29739-12-2-0 .O.J.DÉSAULNIERS.No.224-51 Quebec, March 19, 1951.Application is made to detach from the school municipality of Templeton-East, in the county of Papineau, part of lot No.5, range II ((2) of the township of Templeton, belonging to Mr.Réal Beauchamp, and to annex it to the school municipality of Cousineau, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 29739-12-2 Superintendent of Education.Département du Travail Department of Labour AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements) que la Fraternité Unie des Charpentiers-Menuisiers d'Amérique, local 2457, lui a présenté une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans les comtés de Drummond, Arthabaska et Nicolet, rendue obligatoire par le décret numéro \" 658 du 13 mai 1948.Durant les trente jours à compter de la date de.publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, * GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 24 mars 1951.29735-0 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, local 2457, has submitted to him a request to be accepted as co-contracting party to the collective labour agreement relating to the construction industry in the counties of Drummond, Arthabaska and Nicolet, rendered \u2022 obligatory by the decree number 658 of May 13, 1948.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 24, 1951.29735-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint des métiers de la construction de Joliette, établi en exécution du décret numéro 1407 du 3 avril 1940, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 229 du 7 mars 1951, section \"F\", le tout conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant le mode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er mars 1951 au 28 février 1952, cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: o) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 1407 doivent verser au comité paritaire une somme équivalence à % de 1% de la liste des salaires qu'ils versent à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans assujettis au décret numéro 1407 doivent également payer au comité paritaire une somme équivalente à de 1% 'du salaire établi pour le salarié compagnon le moins rémunéré, soit $25.00 par semaine (salaire minimum fixé par décret).c) Les salariés régis par le décret numéro 1407 doivent verser au comité paritaire une somme équiva'ente à % de 1% de leur salaire.NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Building Trade Joint Committee of Joliette, formed under decree number 1407, of April 3,1940, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 229 of March 7,1951, part \"F\", pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from March 1,1951 to February 28, 1952, it shall be laid in the following manner: o) The professional employers governed by the decree number 1407 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to y& of 1% of the wages paid to their employees governed by the said decree.6) The artisans governed by decree number 1407 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to ^ of 1% of the lowest wage rate established for the journeyman-employee, namely $25.00 per week (minimum wage rate of the decree).c) The employees governed by the decree number 1407 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to ^ of 1% of their wages. 1014 GAZETTE OFFICIELLE DE QLÉBEC, Québec, 21 mars 1961 Tome 88, N° 12 2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les nom, prénoms, et adresse de chaque salarié à leur emploi, sa qualification, les heures de travail, l'argent perçu au cours de chaque semaine et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire tous les mois.ÏTemployeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même la rémunération de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et les faire parvenir lui-même audit comité.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce comité a le pouvoir d'exiger l'assermen-tation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport accompagné des cotisations doit être adressé au Comité paritaire entre le 1er et le 10 de chaque mois.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité conjoint des métiers de la construction de Joliette, pour la période comprise entre le 1er mars 1951 et le 28 février 1952.Le Comité Conjoint des Métiers de la Construction a Joliette Siège social: Joliette, P.Q.État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er mars 1951 et le 28 février 1952.Recettes: Cotisations (Y2 de 1%): Employeurs professionnels.$ 5,900.00 Salariés.:.5,900.00 Artisans (du salaire gagné).1,200.00 Honoraires d'examens.1,200.00 Recettes diverses.800.00 $15,000.00 Dépenses: Administration générale: salaire des employés, inspection, frais de déplacement, loyer, taxes d'affaires, d'eau, éclairage, téléphone, télégrammes, timbres poste et assurance-chômage, entretien de bureaux, administration de banque, etc.$ 8,900.00 Frais de déplacement des membres.2,000.00 Jetons de présence.1,080.00 Bureau d'examinateurs.800.00 Frais judiciaires et professionnels____ 1,100.00 Frais d'impression, vérification et divers.1,120.00 $15,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 24 mars 1951.29735-o 2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with report forms on which shall be mentioned: the name in full and address of every employee in their employ, his competency, the hours of labour, the money collected during any one week and the sums sent to the Parity Committee.The professional employers shall have these forms filled in and sent to the Parity Committee every month.The professional employers shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of their employees, the sums owed to the Parity Committee and forward same themselves to the said Committee.The report of the professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.The committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The report, together with the assessments, shall be sent to the Parity Committee between the 1st and the 10th day of each month.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour, a quarterly report of its financial activities, on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Building Trade Joint Committee of Joliette, for the period between March 1, 1951, and February 28, 1952.The Building Trade Joint Committee of Joliette Corporate seat: Joliette, Que.Estimate of the receipts and disbursements for the period comprised between March 1, 1951 and February 28, 1952.Receipts: Assessments (^ of 1%): Professional employers.$ 5,900.00 Employees.'.5,900.00 Artisans (wages earned).1,200.00 Examination fees.1,200.00 Various receipts.800.00 $15,000.00 Expenses: General administration: (Employees' salaries, inspection traveling expenses, rent, business and water taxes, lighting, telephone, telegrams, postage and unemployment insurance, office upkeep, bank administration, etc.$ 8,900.00 Travelling expenses of members.2,000.00 Meeting expenses.1,080.00 Board of examiners.800.00 Judicial and professional fees.1,100.00 Printing, auditing and miscellaneous.;.1,120.00 $15,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 24, 1951.29735-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March Slth, 1951, Vol.83, No.IS 1015 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travajl, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire des Directeurs de Funérailles de Montréal et du district, établi en exécutis du décret numéro 279 du 4 mars, 1948, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 229, du 7 mars 1951, section \"D\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements, à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant le mode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 13 mars 1951 au 13 mars 1952; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné.a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 279 et amendements doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à ^2 de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 279 et amendements doivent verser au comité paritaire une .somme équivalente à % xde 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré,.soit 850.00 par semaine pour l'embaumeur et $40.00 par semaine pour l'homme de service.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 279 et amendements doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à % de 1 % de leur rémunération, (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doto percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces dernires.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au comité le ou avant le quinze du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au comité paritaire par ses salariés.Le comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective: le comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour hereby gives notice that the Parity Committee of the Funeral Directors of Montreal and District formed under decree No.279 of M arch 4, 1948, has been authorized by a regulation approved, by Order in Council No.229 of March 7, 1951, part \"D\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professionnal employers, the artisans, and the employees governed by the said decree, according the to method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from March 13, 1951, to March 13, 1952, such levy is laid in the following manner : a) The professional employers governed by the said decree, number 279 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% their payroll, for the employees governed by the said decree.b) The artisand governed by the said decree, number 279 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of the lowest wages fixed in the decree for journeymen, namely $50.00 per week for the cmbalmer and $40.00 per week for the service man.c) The employees governed by the said decree, number 279 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to of 1% of their remuneration, (regular wages, percentage, commission, allowance or bonus) 2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which shall be given all information required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete his report, sign and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the latter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity.Committee on or before the 15th of the month following the date of expiration of the period for which it is requir-able; the said reporj, shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The Committee has the right to exact sworn report when deemed advisable.The levy enacted by the present by-law is payable every month by the professional employer, the artisan and the employee: without notice.Upon refusal by a professional employer or an artisan to pay or .to give the necessary information, five days' notice shall be given to them to fulfil their obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of his financial operations to the Minister of La- 1016 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2L mars 1961, Tome 8S, N° 12 Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des Directeurs de Funérailles de Montréal et du district, pour la période comprise \"entre le 13 mars 1951 et le 13 mars 1952.Le comité paritaire des directeurs de funérailles de montreal et du district État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 13 mars 1951 et le 13 mars 1952.Recettes: Cotisations (V2 de 1 %): Employeurs professionnels.$2,200.00 Artisans.'.200.00 Salariés.2,200.00 $4,600.00 Déboursés : Salaires: Secrétariat.$1,020.00 Inspecteurs.1,275.00 Frais de déplacement des inspecteurs 350.00 Frais légaux.250.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.200.00 Vérification des livres.100.00 Assurances et frais de cautionnement 5.00 Frais de déplacement du président et des membres.840.00 Jetons de présence aux membres du comité.'.:.560.00 $4,600.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 24 mars 1951.29735-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, dorme avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire de l'industrie du camionnage de l'Ile de Montréal, établi en exécution du décret numéro 913, du 16 juin 1948, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 228 du 7 mars 1951, section \"C\", à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés, assujettis audit décret suivant la méthode et le taux ci-après: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 15 mars 1951 au 15 mars 1952: cette cotisation s'exerce comme «'dessous mentionné\" a) Les employeurs professicunels régis par ledit décret numéro 913 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ]/2 de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 913 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1/l de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $0.60 de l'heure (ou du salaire moyen fixé par le Comité).bour, on th' following fixed dates: March 31, Juen 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Funeral Directors of Montreal and District, for the period between March 13, 1951, and March 13, 1952.The Pahity Committee of the Funeral Directors of Montreal and District Estimate of the rcccitps and disbursements for the period between March 13, 1951 and March 13, 1952.Receipts: Assessments (^ of 1%): Professional employers.$2,200.00 Artisans.200.00 Employees.2,200.00 $4,600.00 Disbursements : Salaries :' Secretary's office.$1,020.00 Inspectors.1,275.00 Travelling expenses of inspectors .350.00 Legal fees-____,.250.00 Stationary, printing, postage, telephone and telegrams.200.00 Audition.v .100.00 Insurance and Fidelity Bond.5.00 Travelling expenses of chairman and members.840.00 Committee members' attendance fees 560.00 $4,600.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 24, 1951.29735-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Harrette, Minister of Labour hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Trucking Industry Parity Committee for the Island of Montreal, formed under decree number 913 of June 16, 1948, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 228 of March 7, 1951, part \"C\", to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned: 1.Assessments The period of levy shall extend from March 15, 1951 to March 15, 1952; this levy shall be applied as follows: o) The professional employers governed by the said decree, number 913, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to 3^ of 1% of their payroll for the employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the said decree, number 913, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% of the lowest wages established in the decree for journeymen, namely $0.60 per hour (or of the average wage rate established by the Committee). QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March Slth, 1951, Vol.83, No.IS 1017 c) Les salaries régis par ledit décret numéro 913 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% de leur rémunération (salaire fixe, pourcentage, commissions, allocations ou bonis).2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisation, le Comité paritaiic met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exiges par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sut le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 25 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur piofessionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger Passermcntation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement pai l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.» 3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité p ritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie du Camionnage de l'Ile de Montréal, pour la période comprise entre le 15 mars 1951 et le 15mars 1952.Estimé des recettes et des Déboursés du comité paritaire de l'Industrie du camionnage de l'ile de montréal État Hes recettes et des dévoursés probables pour la période comprise entre le 15 mars 1951 et le 15 mars 1952.Recettes: Cotisations (M-de 1%): Employeurs professionnels, salariés et artisans.$49,200.00 Pénalités.300.00 c) The employees governed by the said decree number 913, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to of 1% of their remuneration (regular wages, percentage, commis sions allowances or bonuses).2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which shall be indicated all particulars required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete his report, sign and forward it to the Parity Conunittce every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments laid upon his employees by means of a check off on the latters' wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or boforc the 25th day of the month following the date of expiration of the petiod for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The levy laid by the present by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Upon refusal by a professional employer or an artisan to pay or to give the accessary information, five days notice shall be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committer sluxli submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Trucking Industry Parity Committee for the Island of Montreal, for the period between March 15, 1951' and March 15, 1952.Parity Committee of the Trucking Industry for the Island of Montreal Estimate of the receipts and disbursements for the period, between March 15, 1951 and March 15, 1952.Receipts : Assessments (}-£ of 1%): Professional employers, employees and artisans.$49,200.00 Penalties.300.00 ,$49,500-00 Déboursés: Salaires : Administration et bureau.15,000.00 Inspecteurs.14,000.00 Loyer.2,000.00 Eclairage.125.00 Taxes.100.00 Assurances.\u2022.____ 225.00 Assurance groupe (maladie-addident) 800.00 Papeterie.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.