Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 5 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1951-05-05, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 83, N° 18 1373 Vol.83, No.18 \t\t ¦H\t\t* \t\t \t\t i\t\t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 5 mai 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri-meur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, là vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, may 5th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be pubilshed several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the fins\" Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable 1374 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome 83, N° 18 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de ietarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie Sue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u20141-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SL per dozen.Subscriptions: S7.per year.t N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u20141-52 Lettres patentes Arena de Valleyficld Liée Valleyfield Arena Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mars 1951, constituant en corporation: Henri Crépeau, avocat, C.R., Françoise Gagnon et Yvette Picard., secrétaires, tous trois des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: .Construire, acquérir, exploiter une ou des arenas et tout édifice quelconque, sous le nom de \"Arena de Valleyfield Ltée\" \u2014 \"Valleyfield Arena Ltd.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera «à Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général le quinze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-Q L.DÉSILETS.Letters Patent Arena de Valleyfield Ltée Valleyfield Arena Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of theProvin-ce of Quebec, bearing date the fifteenth day of March, 1951, incorporating: Henri Crépeau, advocate, K.C., Françoise Gagnon and Yvette Pi-card, secretaries, all three of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To build, acquire and operate one or more arenas and other building whatsoever, under the name of \"Arena de Valleyfield Ltée \" \u2014 \" Valleyfield Arena Ltd.\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1961, Vol.83, No.18 1375 Automatic Heat Water & Power Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1951, constituant en corporation: Duncan Kisilcnko, avocat, de Le chine, Allison Arthur Mariotti Walsh, avocat, de Hampstead et Constance Craig, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer Je commerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage, électricité et réfrigération, sous le nom de \"Automatic Heat Water & Power Co.Ltd.\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS' Camille Longpré Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mars 1951, constituant en corporation: Camille Longpré, agent-manufacturier, Cécile Robichon, ménagère, épouse séparée de biens de Camille Longpré, et Guy Laficur, secrétaire, tous de la cité d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: La fabrication et la vente d'agenouilloirs et ornements d'église, sous le nom de \"Camille Longpré Limitée\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.Centre Notre-Dame du Rosaire Incorporé Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: François Jette, agent, Jean Locas, pharmacien, et Eugène Paquet, gérant de banque, tous des cité et district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Administrer et opérer un centre paroissial, social et athlétique, sous le nom de\" Centre Notre-Dame du Rosaire Incorporé\", Le montant auquel sont limités les revenus annuel que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.Cinéma de Lachute Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du Automatic Heat Water & Power Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, incorporating: Duncan Kisilenko, advocate, of Lachine, Allison Arthur Mariotti Walsh, advocate, of Hampstead, and Constance Craig, secretary, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating, electrical and refrigeration contractors, under the name of \"Automatic Heat Water & Power Co.Ltd.\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,C00 shares of $10 each.The head office of the company will be in Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Camille Longpré Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1951, incorporating: Camille Longpré, manufacturer's agent, Cécile Robichon, housewife, wife separate as to property of Camille Longpré, and Guy Lafleur, secretary, all of the city of Outremont, judicial district of Montreal, for the following purposes: The manufacture and sale of kneeling benches and church ornaments, under the name of \"Camille Longpré Limitée\", with a capital stock of $10,000 divided into ,10C0 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L, DÉSILETS, 30027 Deputy Attroney General.Centre Notre-Dame du Rosaire Incorporé Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: François Jette, agent, Jean Locas, druggist, and Eugène Paquet, bank manager, all of the city and judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To manage and operate a parish centre both social and athletic, under the name of \"Centre Notre-Dame du Rosaire Incorporé\".The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.Cinéma de Lachute Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of 1376 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome 88, N° 18 sept mars 1951, constituant en corporation: Hermine Leroux, secrétaire, de Saint-Philippe, Guy Lagardc, agent d'assurances et Giselle Clément, sténographe, tous deux de Lachute, tous du district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: liâtir, acquérir et exploiter des théâtres, sous le nom de \"Cinéma de Lachute Limitée\", avec un capital de 8100,000 divisé en 1,000 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachute, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.City Parcel Delivery Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq mars 1951, constituant en corporation: Seymour Elkin, notaire, de la cité de Westmount, Stanley Stanger, officier d'une compagnie en fiducie, de la ville de Hampstead et George L.Haie, officier d'une compagnie de fiducie, de la cité de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de camionnage et du transport d'articles, objets et marchandises, sous le nom de \"City Parcel Delivery Inc.\", avec un capital de 810,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1188 Preston Lane, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de Mont Çarmcl (Kamouraska) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Louis Massé, Louis St-Onge et Camille Lévesque, tous trois cultivateurs, de Mont-Carmel, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Ouvrir la voie publique depuis la route 2A à St-Philippe de Néri, Comté de Kamouraska, jusqu'au Lac de l'Est, en passant par Notre-Dame du Mont-Carmel, sous le nom de \"Comité d'entretien des Chemins d'Hiver de Mont Car-mel (Kamouraska)\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 810,000.Le siège social de la corporation sera à Mont-Carmel, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.Grissol Export Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date March, 1951, incorporating: Hermine Laroux, secretary, of Saint-Philippe, Guy Lagardc,- insurance agent, and Giselle Clément, stenographer, both of Lachute, all of the judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To build, acquire and operate theatres, under the name of \"Cinéma de Lachute Limitée\", with a capital stock of S100.000 divided into 1,000 shares of S100 each.The head office of the company will be at Lachute, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.City Parcel Delivery Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of March, 1951, incorporating: Seymour Elkin, notary, of the city of Westmount, Stanley Stanger, trust company officer, of the town of Hampstead, and George L.Hale, trust company officer, of the city of Verdun, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of trucking and transporting goods, wares and merchandise, under the name of \"City Parcel Delivery Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1188 Preston Lane, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de Mont Carmel (Kamouraska) Notice is hereby given that under Part in of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eight day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Louis Massé, Louis St-Onge and Camille Lévesque, all three farmers, of Mont-Carmel, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To open the public road from Highway 2A at St-Philippe de Néri, county of Kamouraska, as far as Lac de l'Est, passing through Notre-Dame du Mont-Carmel, under the name of \"Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de Mont Carmel (Kamouraska)\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Mont-Carmel, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.Grissol Export Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol.S3, No.18 1377 du sept mars 1951, constituant en corporation: Paul Caumartin, médecin, de la cité d'Outre^ mont, Allison Villeneuve, et Marcel Bertrand, industriels, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire la fabrication et le commercede produits alimentaires dans toutes leurs spécialités, sous le nom de \"Grissol Export Limited\", avec un capital de S75.000 divisé en 750 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.J.IL Laframboisc & Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des corripagnics'dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1951, constituant en corporation : Joseph-Hugues Laframboisc, agent d'immeubles, Jacques Filion, agent, et Suzanne Renaud, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"J.H.Laframboisc & Compagnie Limitée\", avec un capital de 890,000 divisé en 900 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.day of March, 1951, incorporating: Paul Caumartin, physician, of the city of Outremont, Allison Villeneuve and Marcel Bertrand, industrialists, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in food products, in all the specialties thereof, under the name of \"Grissol Export Limited\", with a capital stock of 875,000, divided into 750 shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.J.II.Laframboisc & Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1951, incorporating: Joseph Hugues Laframboisc, real estate agent, Jacques Filion, agent, and Suzanne Renaud, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name'of \"J.H Laframboisc & Compagnie Limitée\", with a capital stock of 890,000 divided into 900 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.La Cie de Publication Polaris Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mars 1951, constituant en corporation : Gérard Dcnigcr, avocat, Charles Rioux, notaire, et Alice Sanche, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Pratiquer l'industrie et faire le commerce d'imprimeurs, de libraires, de relieurs, d'éditeurs et de publicistes, sous le nom de \"La Cie de Publication Polaris Ltée\", avec un capital de 85,000 divisé en 500 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal,' district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.La Cie d'Immeubles Atlas Atlas Realties Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la rovince de Québec, représenté par M.Alfred lorisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize mars 1951, constituant en corporation: Charles de L.Mignault, Conseil en Loi du Roi, Paul Mignault, comptable, André Mignault, étudiant, et Henri Hunter, employé civil, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: La Cie de Publication Polaris Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1951, incorporating: Gérard Dcniger, advocate, Charles Rioux, notary, and Alice Sanche, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in the trade and business of printers, stationers, binders, editors and publicists, under the name of \"La Cie dc Publication Polaris Ltée\", with a capital stock of 85,000 divided into 500 shares of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.La Cie d'Immeubles Atlas Atlas Realties Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of March, 1951, incorporating: Charles de L.Mighault, King's Counsel, Paul Mignault, accountant, André Mignault, student, and Henri Hunter, civil servant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: 1378 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1951, Tome 88, N° 18 Acquérir, construire, vendre et gérer des immeubles, sous le nom de \"La Compagnie d'Immeubles Atlas\" \u2014 \"Atlas Realties Co.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 3,000 actions sans valeur au pair ou nominale et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $15,000.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize mars 1951.L'Assistant-procureur général.30027-o L.DÉSILETS.To acquire, build, sell and manage real estate, under the name of \"La Compagnie d'Immeubles Atlas\" \u2014 \"Atlas Realties Co.\",; The capital stock of the company will be divided into 3,000 shares without par or nominal value, and the amount of capital stock with which the company will begin its operations is $15,000.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtcnth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.La Ligue des Propriétaires de l'Abord-à- La Ligue des Propriétaires de l'Abord-à-Plouffe Incorporée PIoulïc Incorporée Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Maurice Desrochers, débardeur-officier de police, Paul Simard contracteur ferblantier.François Laurin, ingénieur, Marcel Roy, dessinateur.Gérard Therrien, contracteur, Roger Labrecquc, marchand, Edouard Lemire, électricien, Cléophas Daoust, employé civil, et Marcel Jolicœur, commis, tous de l'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Développer l'esprit civique; protéger la propriété privée, sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires de l'Abord-à-Plouffe Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à l'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quelle, bearing date the eighth day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Maurice Desrochers, stevedore, police officer, Paul Simard, contractor, tinsmith, François Laurin, engineer, Marcel Roy, draughtsman, Gérard Therrien, contractor, Roger Labrecque, merchant, Edouard Lemire, electrician, Cléophas Daoust, civil servant, and Marcel Jolicœur, clerk, all of L'Abord-à-Plouffe, judicial district of Montreal, for the following purposes: To develop a spirit of good citizenship; to protect private property, under the name of \"La Ligue des Propriétaires de l'Abord-à-Plouffe Incorporée\".The amount to which is limited the immovable property which the corporation may hold, is $20,000.The head office of the corporation will be at L'Abord-à-Plouffe, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.Lcd-Mil Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du 3 mars 1951, constituant en corporation: René Leduc, Philias Leduc, marchands, Dame Eugénie DesLierres Leduc, épouse séparée de biens de Philias Leduc et dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et vendeurs de vêtements et habillement de toute description, lainages et soies et cotons et toutes sortes de draps et marchandises en pièce, sous le nom de \"Led-Mil Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune, et 100 actions priviligiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3275 rue Dickson, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 3 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Led-Mil Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1951, incorporating: René Leduc, Philias Leduc, merchants, Dame Eugénie DesLierres, Leduc wife separate as to property of Philias Leduc and duly authorized by him, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in wear and wearing apparel of all kinds, woollens and silks and cottons and all kinds of cloth and piece goods, under the name of \"Led-Mil Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 100 common shares of $100 each, and 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 3275 Dickson Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol S3, No.18 1379 Marcel Le Mat Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 27C, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-six février 1951, constituant en corporation: Samuel Grecnblatt, avocat, Anne Zifkin, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal et Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Outrcmont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme fleuristes, pépiniéristes, jardiniers-maraîchers, fructicultcurs et marchands de graines de semence dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Marcel Le Mat Inc.\" avec un capital de 860,000 divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1314 ouest, rue Stc-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six février 1951.L'Assistant-procu reur général, 30027 L.DÉSILETS.Maristan Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du 6 mars 1951, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, C.R., Manuel Shactcr, avocats et Anne Ross, secrétaire, tous-des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le négoce d'une compagnie de placements, d'immeubles et Gérer des propriétés mobilières et immobilières sous le nom de \"Maristan Corp.\", avec un capital de $100,000 divisé en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, et 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune.^ Le siège social de la compagnie sera à Montréal: district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 6 mars 1951, L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Marcel Le Mat Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of February, 1951, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, secretary, both of the city of Montreal, and Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outrcmont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of florists, nurserymen, market gardeners, fruit growers and seedsmen in all its branches, under the name of \"Marcel Le Mat Inc.\", with a capital stock of 860,000 divided into 400 common shares of the par value of $100 each, and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at 1314 St.Catherine St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of Fcbruarv.1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Maristan Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1951, incorporating: Louis H.Rohrlick, K.C., Manuel Shactcr, advocates, and Anne Ross, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: ' To carry on the business of an investment and real estate company and manage property, moveable and immoveable, under the name of \"Maristan Corp.\", with a capital stock of 8100,000.divided into S00 preferred shares of the par value of $100.each, and 300 common shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Omega Productions Inc.Omega Productions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the third day of du 3 mars 1951 constituant en corporation: March, 1951, incorporating: Henri Beallieu, adv- Henri Beaulieu, avocat et conseil en Loi du Roi, ocate and King's Counsel, Leo Limoges, accoun- Léo Limoges, comptable, tous deux de la cité tant, both of the City of Montreal, and Jean de Montréal, et Jean Beaulieu, avocat et Conseil Beaulieu, advocate and King's Counsel, of the en Loi du Roi, de la cité d'Outremont, tous du City of Outremont, all in the Judicial District of district judiciaire de Montréal, pour les objets Montreal, for the following purposes: suivants: Manufacturer, vendre et faire le commerce Tô manufacture, sell, and operate motion pic-concernant les vues animées, pellicules, caméras tures, films, motion picture cameras, motion pic-pour vues animées, projecteurs de vues animées, ture projecting machines, television apparatus appareils de télévision de toutes sortes, plaques of any type, lantern slides, apparatus, devices, pour lanternes, appareils, et dispositifs sous le under the name of \"Omega Productions Inc.\", nom de \"Omega Productions Inc.\", avec un with a capital stock of $201,000.divided into capital dc $201,000 divisé en 40,000 actions 40,000 preferred shares of the par value of $5.privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune each, and 1,000 common shares of the par value ct 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair of $1.each, de $1 chacune. 1380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1951, Tome 83, N° 18 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 3 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Perfect Paper Box Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du 3 mars 1951, constituant en corporation: Dame Eugenia Zlotnicka, marchande publique, épouse séparée de biens de Adolf Zebcrko, de la ville de Mont-Royal, Stanislaw Waga, manufacturier, et Dame Rena Brun, marchande publique, épouse séparée de biens de Stanislaw Waga, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le négoce et le commerce de manufacturiers et négociants de boîtes de papier, cartons, boîtes de carton et réceptacles de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Perfect Paper Box Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en S00 actions d'une valeur de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Dats du bureau du Procureur général, le 3 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Quebec Metal Corporation Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1951, constituant en corporation: Gilles de Billy, avocat, tie Sillery, Claude Gagnon, avocat, Jean-Baptiste Brown, comptable, Alice Guntensperger, secrétaire, tous trois de la cité de Québec et Thérèse Sirois, secrétaire, de la cité de Lauzon, tous du district judiciaire tie Québec, pour les objets suivants: Faire des recherches et ties explorations afin de découvrir des mines et tics minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Que-bec Metal Corporation Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital tie 83,500,000 divisé en 3,500,000 actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà au montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions; Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire tie Québec.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Quebec Sack Supply Ltd.Avis est tlonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Datetl at the office of the Attorney General, this third day of March, 1951.L.DÉSILETS 30027-o Deputy Attorney General.Perfect Paper Box Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing tlate the third day of March, 1951, incorporating: Adolf Zeberko, manufacturer, Dame Eugenia Zlotchicka, marchande publique, wife separate as to property of Adolf Zeberko, of the Town of Mount-Royal, Stalislaw Waga, manufacturer, and Dame Iiena Brun, marchande publique, wife separate as to property of Stanisla Waga, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on trade and business of manufacturers and general jobbers of paper boxes, cartons, cardboard boxes and containers of all kinds and descriptions, under the name of \"Perfect Paper Box Ltd.\", with a capital stock of 840,000.divided into 800 shares of S50.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Quebec Metal ^Corporation Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, bearing date the eighth day of March, 1951, incorporating: Gilles tie Billy, advocate, of Sillery, Claude Gagnon, advocate, Jean-Baptiste Brown, accountant, Alice Guntensperger, secretary, all three of the City of Quebec, antl Thésèse Sirois, secretary, of the City of Lauzon, all in the Judicial district of Quebec, for the following purposes: To prospect antl explore for mines and minerals; To carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raisctl, washed, cradled, smelted, refined crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; antl sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Quebec Metal Corporation Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of 83,500,000.divided into 3,500,000 shares of SI.each.The shareholders shall incur no personal responsabilité' in excess of the amount of the price paid or agreetl to be paid to the company for its shares; The head office of the Company will be at Quebec, Judicial District of Quebec.Datetl at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Quebec Sack Supply Ltd.Notice is hereby giventhat under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol.83, No.18 1381 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du 6 mars 1951, constituant en corporation: Jack Clapofl\", marchand, Dame Bessie Prepas, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jack ClapofF, et Sam, Schwarz Bard, avocat, tous de la cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre et faire le commerce de sacs, poches, de laine, coton, tissus, lainages, soieries, toiles et vêtements de toute sorte, sous le nom de \"Quebec Sack Supply Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 100 Monseigneur Gauvreau, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le 6 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1951, incorporating: Jack Clapoff, merchant, Mrs Bessie Prepas, wife contractually separate as to property of the said Jack Clapoff, and Sam Schwarz Bard, advocate, all of the City and Judicial District of Quebec, for the following purposes: To manufacture, buy and deal in or with bags, sacks, wool, cotton, fabrics, woollens, silks, linens and clothing of every sort, under the name of \"Quebec Sack Supply Ltd.\", with a capital stock of 840,000.divided into 1,000 common shares at a par value of $10.each, and 3,000 preferred shares at a par value of $10.each.The head office of the Company will be at 100, Monseigneur Gauvreau, Quebec, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Rainville Automobiles Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1951, constituant en corporation: Albert Rainville, garagiste, Dame Berthe L'Homme, ménagère, épouse commune en biens dudit Albert Rainville, et Gérard Chicoine, comptable tous de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: D'opérer le commerce comme marchands ou agents d'automobiles, et véhicules de toute description, moteurs, radios et accessoires électriques, instruments aratoires; opérer un garage, sous le nom de \"Rainville Automobiles Limitée\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.Rainville Automobiles Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1951, incorporating: Albert Rainville, garage keeper, Dame Berthe L'Homme, housewife, wife, common as to property of said Albert Rainville, and Gérard Chicoine, accountant, all of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To carry on business as dealers in or agents for automobiles and vehicles of every description, motors, radios and electric appliances, form implements; to operate a garage, under the name of \"Rainville Automobiles Limitée\", with a capital stock of $100,000 divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.Ross and Kenia Limited Avis est donné qu'en vertu de là première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1951, constituant en corporation; Hector Ross, agent, Dame Jeannette Grenier Ross, ménagère, épouse dudit Hector Ross, Lau-rette Ross, commerçante, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'entrepreneur et constructeur en général, sous le nom de \"Ross and Kenia Limited\", avec un capital de $38,000 divisé en 3,800 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2111, rue Préfontaine, Montréal, district judiciaire de Montréal, \u2022 Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.Ross and Kenia Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1951, incorporating: Hectsr Ross, agent Dame Jeannette Grenier Ross, housewife, wife of said Hector Ross, Laurette Ross, trader, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and trade of general contractor and builder, under the name of \"Ross and Kenia Limited\", with a capital stock of $38,000, divided into 3,800 shares of 810 each.The head office of the company will beat 2,111 Préfontaine Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.St.Laurent Drive Yourself Ltd.St.Laurent Drive Yourself Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have 1382 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 5 mai 1951, Tome 83, N° 18 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mars 1951, constituant en corporation: Yvon Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau et Rita Dufresne, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le négoce de loueurs et locateurs d'au-tomibiles et véhicules; conduire et exploiter sous toutes ses formes que ce soit une entreprise de transport et exploiter des garages, sous le nom de \"St.Laurent Drive Yourself Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 800 actions communes de S5 chacune et en 360 actions privilégiées de 8100.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quinze mars 1951.L'Assistant-procuteur général, 30027-o L.DÉSILETS.Taché Lake Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1951, constituant en corporation : Kenneth Albert Wilson, John McGlinchcy Home, avocats et conseils en loi du Roi, Kenneth Hunter Wilson, avocat, Helen Hague et Helen Gormley, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations afin de découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"Taché Lake Mines Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de 83,000,000 divisé en 3,000,000 d'actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie lionises actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027 L.DÉSILETS.Textile Ste-Anne Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compangies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: René Dcguire, avocat, Charles-Emile Bruchési, avocat, tous deux d'Outrcmont, et Thérèse Sénéchal, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et la fabrication de toutes sortes de tissus et textiles quelconques, sous le nom de \"Textile Ste-Anne Limitée\", avec un capital de $100,000 divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 6,000 actions privilégiées de $10 chacune.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date' the fifteenth day of March, 1951, incorporating: Yvon Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau and Rita Dufresne, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of lessors and renters of automobiles and véhicules; to conduct and operate, in all lines of same, a transportation business and operate garages, under the name of \"St.Laurent Drive Yourself Ltd.\", with a capital stock of 840.000 divided into S00 acommon shares of $5 each and 360 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.Taché Lake Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1951, incorporating: Kenneth Albert Wilson, John McGlinchey Home, advocates and King's Counsel, Kenneth Hunter Wilson, advocate, Helen Hague and Helen Gormley, secretaries, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, wahed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Taché Lake Mines Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of 83,000,000.divided into 3,000,000 shares of SI.each.The shareholders of the company shall incur no personal responsability in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares; The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027-o Deputy Attorney General.Textile Ste-Anne Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951, incorporating: René Deguire, advocate, Charles Emile Bruchési, advocate, both of Outremont, and Thérèse Sénéchal, secretary, of Montréal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in and manufacture fabrics and textiles of any kind whatsoever, under the name of \"Textile Ste-Anne Limitée\", with a capital stock of 8100,000, divided into 4,000 common shares of S10 each, and 6,000 preferred shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vo.l 83, No.18 1383 Le siège social de la compagnie sera à Rigaud, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.The head office of the company will be at Rigaud, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.The American Material Handling Society The American Material Handling Society Inc.Montreal Chapter Inc.Montreal Chapter Avis est donné qu'en vertu de la troisième Notice is hereby given that under Part III partie de la Loi des compagnies de Québec, il a of the Quebec Companies' Act, letters patent été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la have been issued by the Lieutenant-Governor of province de Québec, des lettres patentes en date the Province of Quebec, bearing date the seventh du sept mars 1951, constituant en corporation day of March, 1951, incorporating withoutshare sans capital-actions: Douglas A.Gillespie, surin- capital: Douglas A.Gillespie, building superintendant d'édifice, de St-Lambert, Col.Eric D.tendent, of St.Lambert, Col.Eric, D.Elwood, Elwood, M.B.E., soldat, John G.Pope, Q.B.E., M.B.E*.soldier, John G.Pope, O.B.E.engineer, ingénieur, tous deux de la cité de Montréal, tous both of the City of Montreal, all in the Judicial du district judiciaire de Montréal, pour les objets District of Montreal, for the following purposes: suivants: Améliorer par divers moyens la théorie et la To advance the theory and practice of Material pratique des arts et sciences se rapportant à la Handling and allied arts and sciences by various manutention industrielle et commerciale (Mate- means, under the name of \"The American Material Handling): sous le nom de \"The American rial Handling Society, Inc.\" Montreal Chapter\".Material Handling Society, Inc.\"Montreal Chapter\".Le montant auquel est limitée la valeur des The amount to which the value of the immo- biens immobiliers que la corporation peut possé- vable property which the corporation may possess, der est de $30,000.\u2022 is to be limited, is $30,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, The head office of the Corporation will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le sept Dated at the office of the Attorney General, mars 1951.this seventh day of March, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 30027 L.DÉSILETS.30027-o Deputy Attorney General.The Laurentian Hide Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: Henri-Paul Marcotte, industriel, Maurice Marcotte, chimiste, du Lac Beauport, et Jean Poirier, comptable agréé, de la cité de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de peaux vertes de toutes sortes, sous le nom de \"The Laurentian Hide Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Quél>ec.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30027-o L.DÉSILETS.The Laurentian Hide Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: Henri Paul Marcotte, industrialits, Maurice Marcotte, chemist, of Lake Beauport, and Jean Poirier, chartered accountant, of the city of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in raw hides of all kinds, under the name of \"The Laurentian Hide Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Provincial Secretary, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30027 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Cécile Snyder Incorporated Cécile Snyder Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies Act, supplementary letters été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la patent, bearing date the 4th day of April, province de Québec, des lettres patentes supplé- 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of mentaires en date du 4 avril 1951 à la compagnie the Province of Quebec, to the company \"Cécile \"Cécile Snyder Incorporated\", ratifiant son re Snyder Incorporated\", ratifying its By-Law No.glement No.24, augmentant son capital de $13,- 24 increasing its capital stock from $13,000 to 000 à $53,000 par la création de 400 actions privi- $53,000 by the creation of 400 preferred shares légiées de $100 chacune, sujettes aux droits et of $100 each, subject to the rights and restric- restrictions énumérés audit règlement.tions enumerated in the said by-law. 1384 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome S3, N° 18 Daté du bureau du Procureur général, ce avril 1951.L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.Columbia Frame Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 5 avril 1951, à la compagnie \"Columbia Frame Incorporated\", ratifiant son règlement No.23, augmentant son capital de 820,000 à 8120,000 par la création de 100,000 actions privilégiées de SI chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionnées audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 5 avril 1951, L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.J.A.Thibault & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 mars 1951, à la compagnie \"J.A.Thibault & Fils Ltée\", ratifiant son règlement N° 35 étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur-général, le 30 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30028-o L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this 4th day of April, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.Columbia Frame Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 5th day of April, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Columbia Frame Incorporated\", ratifying its By-Law No.23 increasing its capital stock from S20.000 to 8120,000 by the creation of 100,000 preferred shares of SI each, subject to the rights and restrictions mentioned in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 5th day of April, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.J.A.Thibault & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the thirtieth day of March, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"J.A.Thibault & Fils Ltée\", ratifying its By-law No.35, extending its powers.Dated at theoffice of the Attorney General, this thirteith day of March, 1951.L.DÉSILETS.30028 Deputy Attorney General.John Millen Trois-Rivières Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 3 avril 1951, à la compagnie \"John Millen Trois-Rivières Limitée\", ratifiant son règlement spécial \"D\" augmentant son capital par la création de 1,200 actions additionnelles sans valeur nominale ou au pair, et fixant à 812,000 le montant avec lequel la compagnie exercera son commerce.Daté du bureau du Procureur général, le 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.John Murdock & Fils, Ltée John Murdock & Son Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres supplémentaires, en date du 4 avril 1951, à la compagnie \"Les Industries du Lac St-Jean, Ltée\" \u2014 \"Lake St.John Industries Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes du 20 janvier 1942, ratifiant: 1°) son règlement no 10: a) changeant son nom en celui de \"John Murdock & Fils, Ltée\" \u2014 \"John Murdock & Son Ltd.; b) changeant l'endroit du siège social et de la principale place d'affaires de la compagnie de Saint-Félicien à Chi-coutimi; 2°) son règlement no 11: a) refondant les 100,000 actions ordinaires de la compagnie, de SI chacune, en 1,000 actions de ordinaires S100 chacune; b) refondant et convertissant ses 44,950 actions privilégiées de S20 chacune en 8,990 actions ordinaires de S100 chacune.John Millen Trois-Rivieres Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of April, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"John Millen Trois-Rivières Limitée\", ratifying its special bylaw \"D\" increasing its capital by the creation of 1,200 additional shares without nominal or par value, and fixing at 812,000 the amount with which the company will carry on business.Dated at the office of the Attorney General, this 3rd day of April, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.John Murdock & Fils, Ltée John Murdock & Son Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the fourth day of April, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Industries du Lac St-Jean, Ltée\" \u2014 \"Lake St.John Industries Ltd.\", incorporated by letters patent on January 20th, 1942, ratifying: 1) its By-law No.10: a) changing its name to that of \"John Murdock & Fils, Ltée\" \u2014 \"John Murdock & Son Ltd.\"; b) changing the place of the head office and principal place of business of the company from Saint Félicien to Chicoutimi; 2) its By-law No.11a) transforming the 100,000 common shares of the company of 81 each, into 1,000 common shares of 8100 each; b) transforming and converting its 44,950 preferred shares of S20 each, into 8,990 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol.83, No.18 1385 Daté du bureau du Procureur general, le 4 Dated at the office of the Attorney General, avril 1951.this fourth day of April, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 30028-o L.DÉSILETS.30028 Deputy Attorney General.Marlcnc Dress Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 30 mars 1951, à la compagnie \"Marlcne Dress Incorporated\", ratifiant: 1°) son règlement N° A, augmentant le nombre de ses directeurs de trois à quatre; 2°) son règlement N° B: a) créant et émettant 100 actions ordinaires de 8100 chacune du capital autorisé de la compagnie sous la forme de 100 actions privilégiées de 8100 chacune; b) augmentant ledit capital autorisé de 820,000 à 800,000 par la création de 400 actions privilégiées additionnelles de 8100 chacune; c) énumérant les droits, restrictions et privilèges attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le 30 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.M.Schlcien Inc.Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 6 avril 1951, à la compagnie \"M.Schlcien Inc.\", ratifiant son règlement \"A\", augmentant son capital autorisé de $40,000 à 880,000 par la création de 4,000 actions privilégiées de 810 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 0 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.Marlcne Dress Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of March, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Marlcnc Dress Incorporated\", ratifying : 1.) its By-law No.A increasing the number of its directors from three to four; 2.) its By-law No.B: a) creating and issuing 100 common shares of 8100 each of the company's authorized capital under the form of 100 preferred shares of 8100 each; b) increasing said authorized capital from $20,000 to 800,000 by the creation of 400 additional preferred shares of 8100 each; c) enumerating the rights, restrictions and privileges attaching to the preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this 30th day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.M.Schleien Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 0th day of April, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"M.Schleien Inc.\", ratifying its By-law \"A\" increasing its authorized capital from $40,000 to 880,000 by the creation of 4,000 preferred shares of S10 each, comprising the rigths, restrictions and privileges mentioned in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 0th dav of April, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.Nadelle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 3 avril 1951, à la compagnie \"Nadelle Inc\", ratifiant son règlement No.27, augmentant son capital autorisé de 820,000 à 8100,000 par la création de 800 actions privilégiées, sujettes aux droits, restrictions et privilèges énumérés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.Roy & Fils Limitée Roy & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 avril 1951, à la compagnie \"Roy & Fils Limitée\" \u2014 \"Roy & Son Limited\", ratifiant son règlement No 1A portant son capital-actions de $20,000 à $00,000 par la création de 400 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes Nadelle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of April, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Nadelle Inc.\", ratifying its By-Law No.27 increasing its authorized capital from S20.000 to S100.000 by the creation of 800 preferred shares, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 3rd day of April, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.Roy & Fils Limitée Roy & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the sixth day of April ,1951, were issued by the Lieutenant-Governor'of the Province of Quebec, to the company \"Roy & Fils Limitée\" \u2014 \"Roy & Sons Limited\", ratifying its By-law No.1A raising its capital stock from 820,000 to 860.000, by the creation of 400 preferred shares of 8100 each, subject to the 138G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome 83, N° 18 aux droits et restrictions indiqués audit règlement Daté du bureau du Procureur général, le 6 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 3002S-o L.DÉSILETS.The Taras Shcvchenko Ukrainian Reading Society Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, (les lettres patentes supplémentaires en date du G avril 1951, ù \"The Taras Shevchenko Ukrainian Reading Society\", étendant ses pouvoirs à cette corporation en augmentant à $150,-000 la valeur des biens mobiliers qu'elle peut acquérir et posséder.Daté du bureau du Procureur général, le 6 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 30028 L.DÉSILETS.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 45G Québec, le 26 avril 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant une convention collective de travail relative à l'industrie de la fabrication des produits de métal en feuilles dans l'Ile de Montréal et un rayon de 15 milles de ses limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part : La Chambre de Construction Inc., Section de la fabrication du métal en feuille, Et, d'autre part: \"The Sheet Metal Workers International Association, Local 116\", pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 17 mars 1951 ; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérante pour l'établissement des conditions de travail dans l'industrie et les métiers visés et la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête; Attendu que les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu qu'une objection a été formulée et qu'elle a été soumise à l'appréciation des parties contractantes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: rights and restrictions indicated into the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of April, 1951.L.DESILETS, 30028 Deputy Attorney General.The Taras Shevchenko Ukrainian Reading Society Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of April, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"The Taras Shevchenko Ukrainian Reading Society\", extending the powers of such corporation by increasing to $150,000 the value of the immoveable property which it may acquire and possess.Dated at the office of the Attorney General, this 6th day of April, 1951.L.DÉSILETS, 30028-o Deputy Attorney General.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 456 Quebec, April 26, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council Concerning a collective labour agreement relating to the sheet metal fabricating industry in the Island of Montreal and a radius of 15 mile from its limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a request to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: The Builders' Exchange Inc., Sheet Metal Fabricating Section, And, on the other part: The Sheet Metal Workers International Association, Local 116, for the employers and the employees of the industry and the trades concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of March 17,1951; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance for the establishing of working conditions in the industry and the trades concerned and in the territorial jurisdiction indicated in the said request; Whereas the provisions of the Act have been duly observed as regards the publication of notices; Whereas one objection has been raised and it has been submitted to the contracting parties for consideration; It.is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, 4» QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol 83, No.18 1387 Que ladite requête soit acceptée conformément That the said request he accepted in pursuance aux dispositions de la Loi de la convention col- of the provisions of the Collective Agreement lective (Statuts refondus de Québec, 1941, cha- Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter pitre 103 et amendements) avec, toutefois, les 103 and amendments) with, however the follow -nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des ing new provisions to be substituted for the con-conditions décrites dans la Gazette officielle de ditions described in the Quebec Official Gazette, Québec, édition du 17 mars 1951.issue of March 17, 1951.I.Définitions: Pour des fins d'application du I.Definitions: For the purpose of enforcement décret les mots et termes suivants ont la significa- of the decree, the following words have the tion qui leur est ci-après donnée: meaning hereinafter given to them: a) Le terme \"sous-contremaître\" désigné un sa- a) Assistant Foreman shall be an employée larié nommé par son employeur à cette position et appointed by his employer to such position and dont les fonctions sont d'aider le contremaître his functions shall be to assist the Foreman in dans l'exécution de son travail régulier.the execution of his regular duties./;) Le terme \"chef d'équipe\" désigne un méca- b) A charge hand shall be a mechanic in charge nicien charge de l'exécution d'un travail et qui a of the fabrication of a job and who has a group un groupe de salariés travaillant sous sa juridic- of men working under his direction, tion.c) Le terme \"mécanicien en métal en feuille\" dé- c) A sheet metal mechanic shall be an employee signe tout salarié qualifié qui peut lire les plans et skilled in his trade, competent to work from exécuter, d'après les dessins, toute opération rela- drawings and carry out the fabrication of sheet tive à la fabrication du métal en feuille et des mé- metal and allied materials without direction taux similaires, sans aide ou surveillance.from others.d) Soudeurs: 1° Le terme \"soudeur classe A\" d) Welders: 1.4 Class \"A\" welder is an ein-désigne tout salarié possédant une connaissance ployee with complete knowledge of either oxy-complètc de la soudure acétylène ou électrique de acetylene of electric arc welding of all sheet metal tout métal en feuille ou des métaux similaires et and allied materials, competent to work directly pouvant exécuter lui-même, d'après les plans et from drawings and specifications and able to devis toutes les opérations de son métier, sans carry out operations in his trade without direc-aide ou surveillance.tion from others.Note: Un soudeur qualifié en vertu de l'article Note: A welder qualified under article 25 of 25 des règlements en exécution de la loi des Appa- the regulations for the carrying out of the Pres-reils sous pression et approuvés par le Unfired sure Vessels Act and as approved under the Pressure Vessel Code, édition 1943, doit être con- \"Unfired Pressure Vessels Code, 1943 Edition\", sidéré comme un soudeur de la classe \"A\"; shall be classified as a Class \"A\" Welder.2° Le terme \"soudeur classe \"B\", désigne tout 2.A class \"B\" welder is an employee with salarié possédant une connaissance complète de complete knowledge of either oxy-acetylene or la soudure acétylène ou électrique du métal en electric arc welding of sheet metal and allied feuille ou des métaux similaires et pouvant exé- materials and competent to work directly from cuter, d'après les plans et devis, les opérations de detailed drawings and able to carry out opera-son métier, selon les instructions qu'il reçoit.Hons in his trade with direction from others.3° Le terme \"soudeur classe \"C\" désigne tout 3.A class \"C\" welder is an employee with salarié possédant une certaine connaissance de la knowledge of either oxy-acetylene or electric are soudure acétylène ou de la soudure électrique du welding of sheet metal and allied materials and métal en feuille et des métaux similaires et pou- competent to carry out operations in his trade vaut exécuter les opérations de son métier selon under supervision, les instructions qu'il reçoit.4° Le terme \"soudeur en série\" désigne tout sa 4.\"production welder\" is a workman em-larié affecté à un travail de routine en soudure ployed on routine welding operations and whose dont le taux de salaire est automatiquement ma- rate shall be increased automatically as indi-joré de la façon indiquée à l'article VIL cated in section VIL e) Machiniste: 1° Le terme \"machiniste-méca- é) Machinist: 1.A \"Machinist Mechanic\" shall nicien\" désigne tout salarié qualifié possédant vine be an employee with full knowledge of machine connaissance complète de la machinerie et pou- shop practice and competent to work directly vaut exécuter sur plans et devis toutes les opéra- from drawings and specifications and to carry out tions de son métier, sans aide ou surveillance.any operations in his craft without direction from others.2° Le mot \"machiniste\" désigne tout salarié 2.A \"Machinist\" shall be an employee with qualifié possédant une connaissance complète de full knowledge of machine shop practice and la machinerie et pouvant exécuter sur plans et competent to work directly from drawings and devis toutes les opérations de son métier, sous specifications and to carry out any operations in surveillance.his craft with direction from others./) Le mot \"outilleur\" désigne tout salarié spé- f) A \"Toolmakcr\" shall be an employee enga-cialisé dans la fabrication des poinçons, guides et gcd in the fabrication of dies, jigs and tools.He outils.L'outilleur doit être capable de pro- shall be capable of producing these from working duire ces articles d'après les dessins ou esquisses drawings or sketches, using standard tool room en employant l'outillage régulier de l'atelier, sans equipment without direction from others, aide ou surveillance.g) Le terme \"compagnon peintre\" désigne tout g) \"Journeyman Painter\" shall be an em-salarié qui a toute l'expérience voulue pour pein- ployee who is thoroughly experienced in painting turer les métaux et autres matériaux de même na- metal and allied materials by brush, spray turc, soit au pinceau, au pistolet ou par immer- and dipping methods, and in the cleaning and sion et pour faire le nettoyage et la cuisson néces- baking procedure necessary.He shall be com-sairc.Il doit pouvoir préparer les couleurs et petent to blend colors and mix his own paint, mélanger sa propre peinture et avoir été engagé ahd shall have been employed specifically as a spécifiquement comme peintre.painter.h) Le terme \"peintre au pistolet\" désigne tout h) \"Spray Painter\" shall be an employee salarié travaillant durant au moins 70% de son engaged a minimum of 70% of his time in spray 1388 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome 82, N° 18 temps ù peinturer au pistolet et qui peut mélanger la peinture utilisée ytour cette opération et prendre soin du pistolet.ï) Le mot \"forgeron\" désigne tout salarié capable d'exécuter le travail appartenant au métier de forgeron.j) Les mots \"préposé aux machines\" désignent tout salarié capable de monter et d'ajuster sa machine pour les opérations ordinaires à exécuter et de voir au fonctionnement de sa machine d'une façon compétente.Les préposés à la cisaille mécanique, à la plieuse et découpeuse mécanique ou à la machine à rouler (roll forming)\u2014 à l'exception de la machine à ourler (lock former) Pittsburg \u2014 sont considérés comme préposés aux machines» k) Les mots \"assembleur\" et \"ouvrier spécialisé\" désignent tout salariés qui peuvent exécuter toute opération d'après les instructions, lire les détails apparaissant sur les plans et exécuter des travaux requérant moins de compétence que ceux qu'exécutent les ouvriers qualifiés./) Le terme \"ouvrier de la productiori\" désigne tout salarié qui, ayant reçu l'entraînement nécessaire, exécute du travail ayant trait à la fabrication en série, lequel requiert moins d'expérience que celui des assembleurs et ouvriers spécialisés; tel salarié n'est pas requis de lire les détails sur les plans.Par \"fabrication en série\", on entend une fabrication qui nécessite la répétition des mêmes opérations plusieurs fois durant la même journée.m) Le terme \"chef de groupe\" désigne tout salarié qui n'est pas un mécanicien et qui est chargé de la direction d'un groupe d'hommes en vue de l'exécution d'instructions déterminées tombant sous le coup de sa propre classification ou d'une classification inférieure.n) Aides: Les aides sont des salariés qui assistent et qui aident les ouvriers qualifiés appartenant à une classification supérieure à celle des ouvriers de la production.o) Apprentis: Les apprentis sont des garçons ou jeunes gens de 16 à 21 ans; ils reçoivent un carnet d'apprentissage du Comité paritaire.Ce carnet doit être dûment rempli par les employeurs avec mention des périodes de travail dans le métier.p) Garçons: Les garçons de 16 à 18 ans inclusivement peuvent être affectés à un travail de routine, aux taux établis pour les apprentis dans le paragraphe \"i\" de l'article VII, jusqu'à ce qu'ils atteignent le taux régulier des aides.Par travail de routine, on entend le travail des messagers, des commissionnaires ou autre occupation de semblable nature.Si un garçon est placé dans une autre classification, il doit être rémunéré en conséquence.Les garçons autres que ceux affectés à un travail de routine ne peuvent, toutefois, dépasser en nombre le cinquantième des salariés de l'établissement.q) Divers: Les salariés employés régulièrement comme expéditeurs, hommes d'entrepôts ou magasiniers doivent recevoir $0.05 l'heure de plus que le taux minimum des aides.Le salarié en charge de ces départements doit recevoir 80.15 l'heure de plus que le taux minimum des aides.Toutefois, les salariés employés temporairement à ces fonctions continuent de recevoir leurs taux réguliers de salaire.r) Le terme \"polisseur classe A\", désigne un salarié qui polit les métaux et alliages de formes variées sans en altérer la forme et les contours; prépare les colles et autres bases adhérentes choisit les différents abrasifs; forme et ajuste les meules en vue d'obtenir un rendement uniforme.painting and capable of mixing the pa'nt to be used in said operation and of taking care of the spray gun.i) A \"Blacksmith\" sha'l be an employee capable of doing the usual work appertaining to the trade of blacksmith.j) A \"Machine Operator\" shall be an employee competent to set up and adjust his machine for ordinary operations to be performed and to operate his machine in a skillful manner.Workmen who operate a power shear, power brake or roll forming machine (with the exception of Pittsburg Lock Former) shall be classified as Machine Operators.k) \"Assemblers and Specialists\"^ shall be employees competent to carry out operations according to instructions had shall be able to read detailed drawings and engage in work requiring less skill than a journeyman.I) \"Production Workers\" shall be employees occupied under supervision in repetitive work that requires less skill than the qualifications of assemblers and specialists; they shall not be required to read detailed drawings.The words \"repetitive work\" shall mean repeated operations several times a day.m) \"leading hand\" shall be an employees who is not a mechanic and who is handling a group of men to carry out specific instructions within the scope of his own or a lesser classification.n) \"Helpers\" shall be employees occupied to help and give useful assistance to a more experienced workman classified above the classification of production workers.o) \"Apprentices\" shall be boys or young men between the ages of sixteen and twenty-one and they shall received an apprenticeship book from the Joint Committe.Said book shall be properly filed by employers, crediting time worked at trade.p) Boys: Boys between the ages of 16 and 18 inclusively may be employed for routine operations at the rates set for apprentices in section VH-i until such time as they acquire the standard rate for helpers.Routine operations shall comprise such work as messengers, stock-chasers and the like.If a boy be placed in any other classification he shall be paid accordingly.% Boys other than those employed on routine operations may, however, be employed at a ration not greater than one to every 50 employees in the plant.q) Miscellaneous:Workman regularly employed as shippers, warehousemen, or stock keepers shall be paid .05 per hour in excess of the helpers' minimum rate.The employee in charge of these department shall be paid $0.15 per hour in excess of the helpers' minimum rate.However, workmen temporarily employed as above shall retain their regular rates of pay.r) \"Class \"A\" Buffer and Polisher\" shall be a workman who polishes and buffs metal and aloys of usual and unusual design and shape maintains^ contours and shape within reasonable dimensions, prepares glue or other grain lock, selects various abrasives, heads and balances polishing and abrasive wheels for uniformity of production. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol 83, No.18 1389 II.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend l'Ile de Montréal et un rayon de quinze (15) milles de ses limites.III.Juridiction industrielle et professionnelle: a) Le décret s'applique à tous les établissements s'occupant de la fabrication des produits de métal en feuille.Les produits de métal en feuille comprennent tout matériel usiné ou article fabriqué entièrement ou en majeure partie de métal en feuille d'une épaisseur variant de .0043 de pouce à .1875 de pouce.Le métal en feuille désigne l'acier et le fer ainsi que tout métal non-ferreux ou alliage.b) Le décret ne s'applique pas aux établissements industriels et à leurs salariés déjà régis par une convention collective de travail rendue obligatoire par décret, en vertu de ladite loi, ni à la fabrication des poêles et/ou des fournaises dans les fonderies reconnues comme telles.Il ne s'agit pas des établissements ayant comme production principale l'équipement destiné aux fabricants de sucre et de sirop d'érable.IV.Durée du travail: a) La semaine régulière de travail est de quarante-deux (42|^) heures et demie.La durée journalière ne doit pas excéder huit heures et demie (8%), sans détermination des heures de commencement et de cessation du travail./;) Déductions pour retard: 1° Horloge de présence à la minute: Une déduction de quinze (15) minutes est imposée pour tout retard excédant trois minutes par quart d'heure sur les horloges qui enregistrent les minutes, i.e.pour les retards de quatre (4) à dix-huit (18) minutes, la déduction est de quinze (15) minutes; pour les retards de dix-neufs (19) à trente-trois (33))^ minutes, la déduction est d'une demi-heure et ainsi de suite.2° Horloge de présence ou dixième d'heure: Dans les établissements où ces horloges sont en usage, les salariés doivent poinçonner leur temps dans les six minutes qui précèdent l'heure fixée pour le commencement du travail et dans les six (6) minutes qui suivent la cessation du travail.La déduction imposée pour les retards en regard de ce système est la suivante: quinze (15) minutes pour les retards d'un ou deux points (6-12 minutes)et une demi-heure pour les retards de trois, quatre et cinq points (18-24-30 minutes).V.Travail supplémentaire: a) Tout travail exé cuté en plus de huit heures et demie (8^) par jour et tout travail exécuté le samedi est considéré comme du travail supplémentaire.6) Tout travail supplémentaire doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport au salaire régulier.c) Le double du taux de salaire régulier doit être payé pour tout travail exécuté les dimanches et les jours de fête suivants: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, le 24 mai, la fête de la Confédération, la fête du Travail, le jour d'actions de Grâces, le jour de Noël, ou tout autre jour désigné par une loi ou un décret pour remplacer l'une des fêtes ci-haut mentionnées.Toutefois, à la discrétion des employeurs et des salariés de tout établissement agissant par l'intermédiaire de l'association les représentant, il est permis de substituer à une fête statutaire mentionnée dans le décret une autre journée mutuellement acceptée; dans ce cas, le taux de salaire régulier est payable le jour de congé statutaire mais le taux de salaire double doit être payé le jour convenu.VI.Congés payés: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, le 24 mai, le Jour de la Saint-Jean-Baptbte, la Confédération, la Fôte du Travail, II.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree shall comprise the Island of Montreal and a radius of fifteen (15) miles from its limits.III.Industrial and professional jurisdiction: a) The decree shall apply to all establishments engaged in the manufacture or fabrication of sheet metal products which include all processed material and fabricated articles made entirely or principally from sheet metal of a tickness ranging from .0043 of an inch to .1875 of an inch.Sheet metal shall be considered as meaning steel and iron as well as non-ferrous metals and alloys.b) The decree shall not apply to industrial establishments and their employees already regulated by a collective labour agreement rendered legal and obligatory by decree issued under the authority of the said Act, nor does it apply to stoves and or furnaces manufactured or fabricated by foundries recognized as such.It does not apply to the establishment mainly producing equipment for maple sugar or syrup producers.IV.Standard working hours: The standard working week is one of forty-two and a half (423^) hours.The standard working day consists of eight and a half (8%) hours.There shall, however, be no specified hours of starting and finishing.b) Deductions: 1.Clocks punching minutes: Late starting shall be penalized to the amount of fifteen (15) minutes for lateness in excess of three minutes of each quarter of an hour on clocks which punch in minutes, i.e., for lateness from four (4) to eighteen minutes (18), the penalty will be fifteen (15) minutes, from nineteen (19) to thirty-three (33) minutes, the panalty will be one half hour, etc.2.Clocks punching tenths of hours: On time clocks which punch in tenths of an hour, an employee's time mu>t be punched one (1) point (within six minute.) before starting time and one point (six minutes) after quitting time.Lateness on cards punched on these clocks shall be penalized as follows: employees late one (1) or two (2) tenths of an hour (6 to 12 minutes) shall be penalized fifteen (15) minutes; three (3) four (4) and five (5) tenths (18-24-30 minutes) shall be penalized one half hour.V.Overtime: a) All time worked over eight and half (814) hours in any one day and all time worked on Saturday is overtime./;) Overtime shall be paid at the rate of time and one half of the regular hourly rates.c) Double time shall be paid for all work on Sundays and the following Statutory Holidays: New Year's Day, Good Friday, May 24 Dominion Day, Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day or the day designated by Statute of Decree to be observed as one of the above holidays.However, at the option of the employers and the employees in any establishment acting through the second party, it shall be permissable to substitute for any Statutory Holiday herein specified another day mutually agreed upon, in which event regular rates snail be paid on the Statutory Holiday and double time on the substitute date.VI.Paid holidays: New Year's Day, Good Friday, May 24, St-Jean Baptiste Day, Dominion Day, Lalxmr Day, Thanksgiving Day and 1390 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1951, Tome 83, N° 18 le Jour d'Action de Grâces et Noël, sont des congés payés aux taux réguliers aux conditions suivantes: a) i.Lorsqu'un desdits jours de fête tombe un dimanche, le lundi suivant doit être observé comme un jour de congé payé.ii.Lorsqu'un des jours de congé tombe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, la rémunération est celle d'une journée de travail au taux régulier de salaire.b) Pour avoir droit aux congés, les salariés doivent avoir été au service de l'employeur depuis au moins 30 jours.c) Pour avoir droit à la rémunération, il faut de plus, que les salariés ne soient pas absent le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le congé, exception faite, cependant des absences causées par 1° un décès dans la famille même du salarié; 2° la maladie; 3° une permission écrite de l'employeur; et 4° la participation à un jury.d) Les salariés requis de travailler l'un des jours ci-haut mentionnés doivent recevoir une journée complète de salaire au taux régulier en plus de la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils avaient chômé.\"VII.Salaires: Les taux minima de salaires suivants s'appliquent aux catégories de salariés ci-après énumérées.Aucune des dispositions du décret ne peut avoir pour effet de réduire les taux horaires des salariés actuellement en vigueur.Classifications: Taux horaires a) Compagnons: minima Mécanicien en métal en feuille.81.39 Sous-contremaître.1.52 Chef d'équipe.1.46 Soudeur, classe \"A\".1.46 Soudeur, classe \"IV.1.34 Soudeur, classe \"C\".1.22 Soudeurs en série: Premier semestre.0.98 Deuxième semestre.1.04 Troisième semestre.1.10 Quatrième semestre.1.15 Subséquemment, ils sont éligibles à la classe \"C\", à 81.22 de l'heure, s'ils possèdent les qualifications requises.Polisseur, classe \"A\".1.28 Machiniste.1.22 Mécanicien-machiniste.1.41 Outilleur.1.46 Peintre.\\.1.32 Peintre au pistolet.1.16 6) Forgeron.1.34 c) Préposé au fonctionnement des machi- nes.1.15 d) Assembleur et ouvrier spécialisé.1.22 e) Ouvrier de la production.1.00 /) Aide.0.95 g) Chefs de groupe: Les chefs de groupe doivent recevoir 80.10 l'heure de plus que le minimum établi dans le décret pour leur classification.Les aident qui ont atteint le taux de 81.00 l'heure peuvent être employés régulièrement comme ' ouvriers de la production\", si l'employeur peut le faire.h) Les apprentis tôliers doivent être rémunérés sur la base suivante: Première année: 50% du taux du mécanicien.Deuxième année: 60% du taux du mécanicien.Troisième année: 70% du taux du mécanicien.Quatrième année: 85% du taux du mécanicien.Christmas Day shall be holidays with pay at regular rates.a) i.When a paid Holiday falls on Sunday, the succedding Monday shall be declared a holiday with pay.ii.Payment shall be made for one standard work day at current rates of pay, if such holiday falls on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday of Friday.b) Employees must have been in the service of the employer at least 30 days to qualify.c) Employees must not be absent on the work days immediately preceding and succeeding the Statutory Holiday in order to qualify for payment, exceptions being made for absence due to (a) death in the immediate family; (b)-illness; (c) written permission from the em ployer; and (d) Jury duty.d) Employees required to work on any of the above mentioned holidays shall be paid a full day's pay at regular rates and in addition shall receive the holiday pay that would be paid to them if they had not been employed.VII.Wage rates: The following minimum wage rates shall apply to the respective classes of employment hereunder specified.Nothing contained in the decree shall have the effect of reducing any employee's hourly rate now in force.Classifications: Hourly a) Journeymen: rates Sheet metal Mechanic.'.$1.39 Assistant-foreman.1.52 Charge hand.1.46 Welder Class \"A\".1.46 Welder Class \"B\".1.34 Welder Class \"C\".1.22 Production Welders: First six months.0.98 Second six months.1.04 Third six months.1.10 Fourth six months.1.15 They then become eligible for Class \"C\", at 81.22 per hour, if they qualify.Buffer and Polisher, Class \"A\".$1.28 Machinist.1.22 Machinist mechanic.1.41 Toolmaker.1.46 Painter.1.32 Painter (Spray).1.16 6) Blacksmith.1.34 .c) Machine operator.1.15 d) Assembler and specialist.1.22 e) Production worker.1.00 f) Helper.0.95 g) Leading Hand: Leading Hands shall receive 10c per hour more than the minimum determined in the decree for their classification.Helpers who have attained a wage of 81.00 an hour may be employed regularly as Production Workers, if the employer can arrange accordingly.h) Apprentice sheet metal mechanics shall be paid on the following basis: First year 50% of the Sheet Metal Machanics's rate; Second year 60% of the Sheet Metal Mechanic's rate;.Third year 70% of the Sheet Metal Mechanic's rate; Fourth year 85% of the Sheet Metal Mechanic's rate. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, May 5th, 1951, Vol 83, No.18 1391 i) Les garçons de 16 à 18 ans inclusivement commencent à 80.64 l'heure et reçoivent une augmentation de 80.05 l'heure après chaque semestre de travail ininterrompu.Toutefois, lorsqu'ils atteignent leur 19èmc année, ils doivent être classifies comme aides et rémunérés comme tels.;) Divers Taux horaires Conducteurs de camions, magasinier, homme d'entrepôt, préposé à l'expédition et à la réception des marchandises.$1.00 k) Les salariés faisant partie des équipes de nuit doivent recevoir $0.05 de plus l'heure que les taux ci-haut mentionnés.\" \\ VIII.Taux pour équipes irrégulières: Un boni de cinq cents ($0.03) l'heure doit être payé aux salariés tics équipes irrégulières pourvu que la majeure partie du temps consacré à ces équipes tombe en dehors des heures régulières du travail quotidien de l'établissement ou de l'atelier visé.IX.Vacances payées: a) Tous les salariés qui ont douze mois de service continu pour le même employeur au premier mai, ont droit à une semain-ne de vacances payées à raison de 2% du salaire actuel du salarié lors des vacances; le calcul de la rémunération est basé sur le nombre d'heures régulières de travail (surtemps non-compris) effectuées durant les douze mois précédents.b) Les salariés qui n'ont pas déjà reçu de rémunération de vacances et qui y ont droit parce qu'ils ont travaillé pendant douze mois continus pour le même employeur à la date du premier mai doivent, à la période de vacances, être rémunérés selon le nombre d'heures régulières effectuées de la date de l'embauchage original au trente avril au taux de salaire en vigueur à la date des vacances.c) Tous les salariés qui ont cinq ans ou plus de service pour le même employeur au premier mai ont droit à deux semaines de vacances payées à raison de 4% des heures régulières effectuées durant les douze mois précédents, du premier mai au trente avril, au taux en vigueur à la date des vacances.d) Tous les salariés qui quittent leur emploi avant de prendre leurs vacances annuelles doivent recevoir la rémunération de vacances à laquelle ils ont droit en vertu des présentes dispositions ainsi que celle qu'ils ont gagnée dans l'année courante à la suite de services qualifiés, calculée à compter du premier mai jusqu'à la date de cessation de l'emploi.e) Les salariés qui quittent leur employeur avec plus de douze mois de service pour ce dernier et qui, jusqu'à cette date, n'ont reçu aucune rémunération de vacances ont droit à une rémunération de vacances égale à 2% des heures régulières de travail effectuées à compter de la date de l'embauchage original au taux du salaire en vigueur lors du départ./) Les salariés qui quittent leur employeur après avoir pris leurs vacances doivent recevoir la rémunération de vacances çagnée pendant l'année en cours à la suite de service qualifiés, calculée à compter du premier mai jusqu'à la date de cessation de l'emploi.g) L'employeur peut exiger que l'établissement soit fermé pour la période de vacances; il lui est loisible, également, d'échelonner les vacances de ses salariés en vue de maintenir un rendement continu.Dans ce dernier cas, il doit s'efforcer de plaire à ses salariés lorsqu'il s'agit de fixer la date de leurs vacances.h) Les vacances doivent être prises entre le premier (1er) mai et le trente (30) septembre.Toutefois, après entente entre l'employeur et i) Boys from 16 to 18 shall start at 80.64 cents an hour with increase of $0.05 an hour every six months of continuous service.However, on attaining their 19th year, they shall be classified as helpers and paid as such.j) Miscellaneous: Hourly rates Truck Driver, Stock and Store Keeper, Warehouseman, shipping an'd receiving $1.00 k) Employees working on night shifts shall be paid five cents ($0.05) an hour in excess of the above rates.VIII.Irregular or \"off\" shift rate A premium of five cents (0.05) an hour shall be paid to all workmen employed on any irregular or \"off\" shift provided that the major portion of the time so worked falls outside the regular daily hours of work of the factory or shop concerned.IX.Vacations with pay: a) All employees who have had twelve months continuous service with the same employer as at May first shall be entitled to one week's vacation with pay based on 2% of the employee's actual wage rate at the time of vacation computed on the number of standard hours worked (excluding overtime) during the preceding months.b) Employees who have not previously received holiday pay but who have qualified by having worked twelve months continously for the same employer, upon reaching May first, shall, at the holiday period, be paid for the number of standard hours worked from the date of their original employment to April 30th at the actual wage rate in effect at the time of vacation.c) All employees who have five years or more service with the same employer at May 1st shall be entitled to two weeks' vacation, with pay based on 4% of the standard hours worked during the preceding twelve months from May first at April 30th at the actual wage rate in effect at the time of vacation.d) All employees who leave prior to their vacation for the year, shall receive the vacation pay to which they are- entitled under this plan, plus vacation pay which has been earned during the current year by qualified service, calculated from May 1st to the date of leaving the employ of the employer.e) Employees with more than twelve months service with the same employer who, until that time, have received no vacation pay and who leave the employ of the employer shall be entitled to vacation pay based on 2% of their standard hours worked, computed from the date of their original employment at the actual wage rate at time of leaving.f) Employees who leave after taking their vacation shall receive vacation pay which they have earned during the current year by qualified servide calculated from May 1st to the date of leaving the employ of the employer.g) The employer may require the plant to be closed for the purpose of providing a vacation period or, at his option, may stagger vacation periods of employees so that continuous production may be maintained.In the latter case, the employer shall make every reasonable effort to meet with the wishes of employees in allocating vacation periods.Vacation shall be taken between May 1st and September 30th.\u2022 h) However, subject to mutual agreement between the employees and employer, an em- 1392 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1951, Tome 83, N° 18 le salarié, ce dernier peut prendre ses vacances après le trente (30) septembre.X.Apprentissage: a) La période d'apprentissage est de quatre (4) années; il faut que l'apprenti termine son apprentissage pendant cette période./;) Dans le calcul de cette période de quatre années, tout temps perdu par l'apprenti doit être compensé.A l'expiration de ladite période si, selon l'employeur, l'apprenti ne s'est pas qualifié mécanicien, il peut être requis de travailler une période additionnelle ne dépassant pas six (G) mois.c) Il peut y avoir un apprenti tôlier par deux mécaniciens de métal en feuilles (tôliers) et la même proportion doit être observée dans le cas des machinistes et apprentis machinistes.d) Les apprentis qui ont fréquenté une école régie par la Loi de l'enseignement spécialisé doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études dans les métiers du métal en feuille et au résultat de leurs examens.XI.Retenues: Les retenues sur les salaires, sauf celles requises par la Loi, ne sont faites qu'à la suite d'une autorisation écrite du salarié.XII.Classification: Le salarié est classifié par son employeur, lequel doit fournir à chaque salarié uns carte de classification convenablement remplie et signée.Telles cartes sont fournies par le comité paritaire.Au cas de désaccord, le salarié a l'opportunité de prouver qu'il est compétent pour exécuter le travail de la catégorie pour laquelle il se croit qualifié.XIII.Griefs: Toute mésentente relative au décret et tout grief des salariés sont soumis, par le comité d'atelier, au surintendant de l'établissement; à défaut d'un règlement satisfaisant, le tout peut être soumis à l'employeur concerné.Dans le cas où l'employeur et le comité d'atelier ne peuvent s'entendre, le tout est soumis, par écrit, au Comité paritaire qui est chargé de a mise à exécution du décret.XIV.Lors de la ratification de la présente convention le comité paritaire existant, formé pour surveiller l'application du décret antérieur dans la juridiction territoriale déterminée par la présente convention, demeure en fonction et surveille la mise à exécution de la présente convention jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé.Ce nouveau comité succède à l'ancien et est investi de tous les actifs et droits dudit comité; il assume également toutes les dettes de l'ancien comité en vertu du décret antérieur.XV.Durée du décret: Le décret est valable à compter du jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur pendant une période d'une année après cette date, sans reconduction.A.MORISSET, 30055-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF Numéro 455 Québec, le 26 avril 1951.Présent : Le Lieutenant-gouverneur-en-Conseil Section \"B\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la boîte de carton gaufré dans la Province.ployee may take his vacation after September 30th.X.Apprenticeship: a)The term of indenture shall be four (4) years during which period the apprentice should successively complete his apprenticeship.b) In calculating the four (4) year period, any time lost by the apprentice must be made up.At the end of the four-year period if, in the opinion of the employer, the apprentice has not become a qualified mechanic, he may be required to serve additional time not exceeding six (6) months.c) There may be one sheet metal apprentice to every two sheet metal mechanics, and the same ratio shall apply to apprentice mechinists and machinists.d) Apprentices who have attended a school under the Specialized Schools Act, shall receive a credit in proportion to the duration of their studies in the sheet metal trades and to the results of their examinations.XL Deduction: Deduction from wages except those required by law, shall be made only on written authorization of the employee.XII.Rating: the rating of the employees shall be done by the employer who shall furnish each employee with a classification card properly completed and signed.Such cards will be supplied by the Parity Committee.In case of disagreement, the employee concerned shall be given the opportunity to show whether or not he can qualify for the classification which he seeks.XIII.Disputes: All disputes arising under the decree, and all grievances of employees, shall be submitted by the Shop Committee to the Superintendent of the Plant concerned and, failing settlement, may be brought before the employer affected.Should the employer and the Shop Committee fail to reach an agreement the matter in dispute shall be submitted, in writing to the Parity Committee, administering the decree.XIV.At the time of ratification of the present agreement, the existing Parity Committee formed to administer the former decree in the territorial jurisdiction determined by the present agreement shall remain in office and administer the present agreement unti the formation of a new committee Such new committee succeeds the former one and is vested with all the assets and rights of the said former committee; it also assumes all the liabilities of the former committee, under the previous decree XV.Duration of the decree: The decree comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remains effective for a period of one year from that date without reopening.A.MORISSET, 30055-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNICL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 455 Quebec, April 26, 1951.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"B\" Concerning amendments of the decree relating to the corrugated paper box industry in the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol, 83, No.18 1393 Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton gaufré a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier le décret numéro 561 du 11 mars 1942 et amendements, relatif à la fabrication de boîtes de carton gaufré dans la province de Québec; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 17 mars 1951 ; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modification proposées; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 561, soit modifié comme suit: Les paragraphes \"à\", \"b\", \"c,\" et \"d\" ainsi que l'alinéa 2 du paragraphe \"e\" de l'article II sont remplacés par les suivants: \"«) Salariés: Sexes Taux minima Masculin Féminin Sous-contremaître.80.82 80.58 Machine à gaufrer:.Gaufreur.1.00 Gaufreur temporaire.0.90 Découpeur.0.88 Mécanicien de machine à coller.0.80 Receveur et \"shafter\" de rouleau.0.74 Machine à imprimer et à rainer: Chef-mécanicien.0.96 Mécanicien____.0.88 Assistant-mécanicien.0.80 Receveur et fournisseur .0.74 Presse à imprimer: (sur la longueur) Mécanicien.0.85 Receveur.0.74 Machine à rainer \u2014 Grosses boîtes: Raineur.0.82 0.58 Receveur.0.74 0.52 Machine à rainer \u2014 Petites boîtes: Raineur.0.81 0.56 Receveur.0.74 0.51 Machine à découper les boîtes et marqueuse - mitrailleuse (première opération):.Découpeur.0.82 Receveur.0.74 Machine à découper les feuilles et marqueuse \u2014 mitrailleuse (divers): Mécanicien.0.80 Receveur.0.74 0.51 Machine combinée à découper et à rainer les divisions: Mécanicien.0.82 Receveur.0.74 0.51 Machine simple à rainer les divisions : Raineur.0.78 0.58 Receveur.0.51 Machine à découper les pans : Découpeur.0.80 0.56 Receveur.0.74 0.52 Machine à plier et à appliquer la toile gommée: Mécanicien.0.85 Receveur et inspecteur.0.56 Machine automatique à appliquer la toile gommée : Mécanicien.0.82 Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Joint Committee of the Corrugated Paper Box Industry of Quebec has submitted to the Minister of Labour a request to amend the decree number 561 of March 11, 1942, as amended, relating to the corrugated paper box industry in the province of Quebec; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of March 17, 1951; WHEREAS no objection has been raised against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour.That the said decree, number 561, be amended as follows : Subsections \"a\", \"6\", \"c\" and \"d\" as well as paragraph 2 of subsection \"e\" of section II are replaced by the following: \"a) Employees: Sexes Minimum rates: Male Female Assistant Foreman.SO.82 80.58 Corrugating machine : Operator.1.00 Temporary operator.0.90 Slitter and knife.0.88 Double backer.0.80 Tailer & Roll shatters.0.74 Printer-Slotter machine : Cheif Operator.0.96 Operator.0.88 Assistant operator.0.80 Tailer and feeder.0.74 Printing Press machine: (long-way).Operator.0.85 Tailer.0.74 Large Box slotting machine : Operator.0.82 0.58 Tailer.0.74 0.52 Small box slotting machine Operator.0.81 0.56 Tailer.0.74 0.51 Box slitting & scoring machine: (first way) Operator.0.82 Tailer.0.74 Sheet slitting and scoring machine: (Miscellaneous): Operator.0.80 Tailer.0.74 0.51 Combination partition slitter-slotter: Operator.0.82 Tailer.0.74 0.51 Plain partition slottcr: Operator.0.78 0.58 Tailer.0.51 Flap Cutting machine: Operator.0.80 0.56 Tailer.0.74 0.52 Folder taper: Operator.0.85 Tailer & Inspector.^r^Tl Automatic taping machine Operator.J0.82g|6UOTHEQUE 1394 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 ami 1*951, Tome S3, N° 18 Aide.0.74 Receveur et inspecteur.0.53 Machine semi-automatique à appliquer la toile gommée: Mécanicien.0.5G Receveur et inspecteur.0.51 Machine à appliquer la toile gommée à la main : Mécanicien.0.64 Machine automatique à plier et à piquer: Piqueur.0.80 Machine semi-automatique à piquer: Piqueur.____ 0.74 0.50 Machine à piquer à la main : Piqueur.0.74 0.54 Presse à découper: Découpeur.0.82 Aideetéplucheur.0.74 0.53 Machines non classifiées:.Mécanicien.0.74 0.52 Fournisseur.0.05 0.50 Scie à ruban: Préposé à la se ie à ruban.0.74 0.58 Machine à remonter et à couper: (S.F.) Mécanicien.0.80 0.58 Receveur.0.74 0.51 Matières adhésives : Préposé à la colle.0.82 Presse à rebuts : Presseur.0.74 Aide.0.71 Manutention de rouleaux: Préposé à la manutention mécanique.0.82 Premier préposé à la manutention.0.82 Manutenteur.0.72 Pliage des boîtes: Plicur.0.50 Assemblage et divisions: Assembleuse.0.50 Enveloppement et ficelage : Préposé au ficelage.0.74 0.52 Expédition: Expéditeur.0.853^ Assistant-expéditeur.0.80 Aide et vérificateur.0.72 Chau fleur de camion.0.85 Aide pour chauffeur de camion.0.78 Entretien: .Homme de métier.0.88 Mécanicien.0.85 Huileur.0.74 Gardien.0.72 Concierge.0 72 Chambre de bouilloires: Mécanicien de machine fixe: 2ème classe.0.94 Mécanicien de machine fixe: 3ème classe.0.84 Mécanicien de machine fixe: 4ème classe.0.74 Travail général: Non-classifié.0.65 0.47 b) Salariés (sexe masculin): Nonobstant la cédule de salaires apparaissant au paragraphe \"a\" du présent article, le salaire minimum moyen des salariés du sexe masculin ne doit pas être inférieur à $0.78 de l'heure.c) Salariés (sexe féminin): Nonobstant la cédule de salaires apparaissant au paragraphe \"a\" du présent article, le salaire minimum moyen des salariés du sexe féminin ne doit pas être inférieur à $0.53 de l'heure.Helper.0.74 Tailer & Inspector.0.53 Semi-automatic taper:\t\t\t \t\t\t0.56 Tailer & Inspector.\t\t\t0.51 Hand taper:\t\t\t \t\t\t0.54 Automatic Foldcr-stitcher:\t\t\t \t0\t80\t Semi-automatic stiching ma-\t\t\t chine :\t\t\t \t0\t74\t0.56 Manual stitching machine :\t\t\t \t0\t74\t0.54 Die press machine :\t\t\t Operator.\t0\t82\t Helper & Stripper.Non classified machines :\t0\t74\t0.53 \t\t\t Operator.\u2022.\t0\t74\t0.52 Feeder.\t0\t65\t0.50 Band saw:\t\t\t Operator.\t0\t74\t0.58 S.F.Rcwinder and cutter:\t\t\t Operator.\t0\t80\t0.58 Tailer.\t0\t74\t0.51 Adhesive unit :\t\t\t Operator.\t0\t82\t Waste baling press:\t\t\t \t0\t74\t Helper.\t0\t71\t Roll handling:\t\t\t Machanical roll handler\t\t\t \t0\t82\t \t0\t82\t \t0\t72\t Box folding:\t\t\t \t\t\t0.50 Partition assembly\t\t\t Assembler.\t\t\t0.50 Bundling and tying:\t\t\t Tier.\t0\t74\t0.52 Shipping department:\t\t\t Shipper.\t0\t8oV2\t \t0\t80\t \t0\t72\t \t0\t85\t Driver helper.\t0\t78\t Maintenance:\t\t\t \t0\t88\t Mechanic.\t0\t85\t Oiler.\t0\t74\t \t0\t72\t \t0\t72\t Boiler room:\t\t\t Stationary Engineman\t\t\t \t0\t94\t Stationery Engineman :\t\t\t \t0\t84\t Stationary Engineman :\t\t\t \t0\t74\t General labour:\t\t\t Non classified.\t0\t65\t0.47 b) Male employees: Notwithstanding the preceding schedule of wages, subsection \"a\" of this section, the minimum average wage for male employees shall not be less than 0.78 per hour.c) Female emp'oyees: Notwithstanding the preceding schedule of wages, subsection \"a\" of this section, the average minimum wage for female employees shall not be less than $0.53 per hour. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol.88, No.18 1395 d) Nonobstant la cédule de salaire apparaissant au paragraphe \"a\" du présent article, le salaire minimum moyen pour les salariés des deux sexes ne doit pas être inférieur à S0.70 de l'heure.e) Machine à gaufrer: Le personnel requis pour chaque machine à gaufrer en opération et pour chaque équipe s'il y en a plus qu'une, doit se composer d'un gaufreur, d'un mécanicien de machine à coller (Double-backer), d'un découpeur ou bobineur avec le nombre nécessaire de receveurs et de \"shafter\" de rouleau.Advenant l'absence du gaufreur, le mécanicien de la machine à coller (Double-backer) pourra prendre charge du fonctionnement de la machine comme gaufreur temporaire et devra être rémunéré suivant le taux minimum de cette classification pour une période de six (6) jours consécutifs.Après cette période, il ne doit pas recevoir une rémunération inférieure au taux minimum de salaire du gaufreur jusqu'au retour de celui-ci, alors qu'il doit reprendre ses anciennes fonctions et recevoir son ancien taux de salaire.\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 30058-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 455 Québec, le 26 avril 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans la cité de Saint-Jean et la ville d'Iberville.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans la cité de Saint-Jean et la ville d'Iberville, rendue obligatoire par le décret numéro 329 du 20 février 1947, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 17 mars 1951; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 329, soit modifié comme suit: 1° L'article III est remplacé par le suivant: ''III.Taux de salaires minima: Les taux de salaires minima suivants doivent être payés: Métiers: Taux horaires Briqueteur, plâtrier (travaux ordinaires ou d'ornementation), maçon y compris le tailleur sur le chantier, poseur de blocs de ciment, tireur de joint.$1.37 Finisseur de ciment.1.20 Calfat.1.10 Charpentier, menuisier, mécanicien dans la construction, y compris les opérations suivantes: formes à béton (boutique ou chantier), posage de paravents (bois ou d) Notwithstanding the preceding schedule of wages subsection \"a\" of this section, the average minimum wage for employees of both sexes shall not be less than S0.70 per hour.c) Corrugating machine: Corrugator and liner crew must consist of the following crew members, on each machine and for each shift, if more than one shift is worked: operator, double backer man, knife or clitter man, with necessary tailcrs and roll shafter.In the event of the absence of the operator, the double backer man may operate the machine in capacity of temporary operator at listed minimum for this occupation, for a period of six consecutive days.After this time, he shall receive not less than the minimum scale of pays for an operator until this man returns, at which time he shall revert to his original position (of double backer man) with previous wage scale.\" (Document \"B\" annexed to the order) A.MORISSET, 30058-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 455 Québec, April 26, 1951.Présent: The Lieutenant Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the construction industry in the city of St.John and the town of Iberville.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties tp the collective labour agreement relating to the construction industry in the city of St.John and the town of Iberville, rendered obligatory by the decree number 329 of February 20, 1947, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree, as amended; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of March 17, 1951; Whereas no objection has been raised against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, That the said decree, number 329, be amended as follows: 1.Section HI is replaced by the following: \"IH.Minimum wage rates: The following minimum wage rates shall be paid: Trades : Hourly rates Bricklayer, plasterer (ordinary or ornamental operations), mason including the cutter on the field, cement blocks layer, joint pointer.$1.37 Cement finisher.1.20 Caulker____.____.1.10 Carpenter, joiner, millwright (construction), including the following operations: concrete forms (shop or field), setting or laying of screens (wood or 1396 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1951, Tome S3, N° 18 métal), châssis, fenêtres, \"weatherstrips\", bardeaux (bois ou amiante ou composition), divisions en acier, ameublement, tels que comptoirs et tablettes (fixes ou mobiles), tout papier composition, y compris le posage de plancher en bois, d'amiante gaufré et l'assemblage de maisons préfabriquées.1.10 Limeur de scies.1.10 Grattcur, polisseur, sablcur de plancher à la main ou à la machine.1.10 Poseur de lattes en bois ou en métal.1.10 Électricien \u2014 Compagnon.1 20 Peintre, aspergeur, décorateur, vitrier, tapissier, vernisseur de plancher.1.10 Plombier, poseur d'appareil de chauffage, mécanicien en tuyauterie: Compagnon.1 - 20 Compagnon junior.1.10 Soudeur en tuyauterie (acétylène ou électricité).;.1.20 Poseur de brûleurs à l'huile.1.20 Ajusteur de gicleurs.1.20 Mécanicien en isolement de tuyauterie.1.20 Ouvrier-tôlier et ferblantier-couvreur (boutique ou chantier).1.20 Couvreur \u2014 ardoise, tuile.1.45 Couvreur \u2014 composition, gravier, sable, asphalte.1.10 Homme de chaudière.0.85 Manœuvre, porteur d'oiseau.0.85 Journalier (ouvrier non qualifié).0.S5 Gréeur.110 Préposé au compresseur.1.05 Chauffeur de camion.0 90 Charretier.v.0.85 Préposé au malaxeur à vapeur ou au gros malaxeur à gazolinc.1.20 Préposé au malaxeur à l'électricité ou au petit malaxeur à pazoline.0.85 Poseur d'acier d'armature.1.20 Poseur de liège isolateur.1.25 Finisseur de plancher en mastic.1.15 Poseur de plancher en mastic.1.35 Préposé aux bouilloires (travail de plancher seulement).105 Poseur de tuile en asphalte.1.00 Chauffeur (construction).0.85 Poseur de terrazzo.1.43 Préposé aux machines à polir le terrazzo: Machine à sec.1-28 Machine à l'eau.1.10 Poseur de marbre.1.50 Poseur de tuiles.1.43 Mécanicien île machines fixes ou mobiles.1.05 Conducteur de monte-charge.0.90 Foreur et poudrier.1.10 Machiniste.110 Forgeron sur le chantier.1.10 Préposé aux grues .1.20 Préposé aux pelles mécaniques.1.20 Conducteur de tracteur.1.00 Conducteur de rouleau compresseur (vapeur ou essence).1.00 Conducteur de \"Bulldozer\".1.00 Conducteur de niveleuse.1.00 par semaine Vérificateur de matériel et pointeur.42.00 par heure Surveillant employé également comme chauffeur et devant posséder un certificat de 4ème classe (sans limite de la durée journalière de travail, maximum hebdomadaire 72 heures).1.05 Gardien sur chantier (nuit et jour, sans limite de la durée quotidienne de travail, maximum hebdomadaire 72 heures) 0.65 metal), framework, windows, weatherstrips, shingles (wood, asbestos or composition), steel furniture and partitions such as counters and shelves (fixed or moveable), any composition paper, including the laying of wood floor and corrugated asbestos layer, the erection of prefabricated houses.1.10 Saw filer.1.10 Floor scraper, polisher, sander \u2014 hand or machine.1.10 Lather \u2014 wood or metal.1.10 Journeyman electrician.1.20 Painter, spraying-machine operator, decorator, glazier, paper hanger, floor varnisher.1.10 Plumber, stcamfitter, pipe mechanic: Journeyman.1.20 Jnior journeyman.1.10 Pipe welder (acetylene or electric).1.20 Oil burner fitter.1.20 Sprinkler fitter.1.20 Pipe insulation worker.1.20 Sheet-metal worker and tinsmith-roofer (shop or field).1.20 Roofer \u2014 slate, tile.1.45 Roofer \u2014 Composition, gravel, sand, asphalt .1.10 Boilerman.0.85 Labourer, hod carrier.0.85 Labourer (common worker).0.85 Rigger.1.10 Compressor operator.1.05 Truck driver.0.90 Carter.0.85 Steam mixer operator or large gaxoline mixer operator.1.20 Electric mixer operator or small gazoline mixer operator.0.85 Reinforcing steel erector.1.20 Cork insulation layer.1.25 Mastic floor finisher.1.15 Mastic floor layer.1.35 Kcttleinan (flooring only).1.05 Asphalt, tile layer.1.00 Fireman (construction).0.85 Terrazzo layer.1.43 Terrazzo polishing machine operator: Dry polishing.1.28 Water polishing.1.10 Marble layer.1.50 Tile layer.1.43 Stationary or portable engineman.1.05 Freight elevator operator.0.90 Driller and blaster.1.10 Machinist.1.10 Blacksmith on job.1.10 Crane operator.1.20 Shovel operator.1.20 Tractor operator.1.00 Roller operator (steam or gasoline).1.00 Bulldozer operator.1.00 Grader operator.1.00 per week Material checker and time-keeper.42.00 per hour Watchman, employed also as fireman and required to hold a 4th class certificate (without limitation of the daily hours of work \u2014 weekly maximum of 72 hcurs).1.05 Watchman on job (night and day, without limitation of the daily hours of work, weekly maximum of 72 hours).0.65 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol.S3, No.18 1397 Chauffeur de bouilloire, devant posséder un certificat de 4ème classe.1.00 Porteur d'eau.0.80 Pilonneur, lisseur et épandeur d'asphalte 0.90 Pn'posé à la canalisation, inatcur et soudeur.0.90 2° Le paragraphe \"b\" de l'article IV est remplacé par le suivant: \"b) Les frais de déplacement des salariés envoyés en dehors de la cité de Suint-Jean et de la ville d'Iberville sont à la charge de l'employeur sans pour cela que leur salaire soit réduit.De plus le repas du midi est à la charge de l'employeur si le salarié n'a pas été averti la veille.Les frais de pension doivent également être payés si les salariés ne sont pas ramenés chaque scir dans lesditcs cité et ville.\" 3° Le paragraphe \"e\" de l'article VI est radié.4° L'article Xl-A suivant est ajouté: \"XI-A.Congés payées: a) Définitions: Les termes ci-après mentionnés ont, à moins d'incompatibilité, le sens qui leur est ci-après donné: Employeur: Une personne employant un salarié régi par le présent décret; Commission: La Commission du salaire minimum; Livret de congés: Un livret émis par la Commission, aux fins d'y apposer durant une période de prestations, des timbres de congés payés; Période de prestations : La période s'étendant du premier mai d'une année au trente avril de l'année suivante; Timbre: La marque imprimée ou vignette émise par la Commission, pour représenter les prestations de congés ducs par un employeur.b) Droits du salarié : 1.aux congés payés : Tout salarié, régi par le présent décret, ayant été au service continu d'un employeur durant une période de prestations, a droit à la fin de telle période, à un congé d'une durée minimum de sept jours consécutifs et à la rémunération pour congés ci-après fixée: 2.« réimmération pour congés : Tout salarié régi par le présent décret, n'ayant pas été au service continu d'un employeur durant une période de prestations, a droit, à la fin de telle période, seulement à la rémunération pour congés ci-après fixée.c) Prise de congé : L'employeur doit donner à son salarié y ayant droit, le congé prévu par le présent article, dans les quatre mois qui suivent la date de la fin d'une période de prestations.(/) Rémunération pour congés : La rémunération pour congés à laquelle a droit un salarié régi par le présent décret, représente, pour une période de prestations, la valeur des timbres ap-po.'és, pour telle période, dans son livret de congés.e) Apposition, de timbres : Tout employeur doit apposer à l'échéance de chaque paie de son salarié, dans le livret de congés de ce dernier, des timbres pour une valeur égale à deux pour cent (2%) du montant brut de telle paie./) Obligations de l'employeur : Tout employeur doit: 1) se procurer de la Commission avant le commencement d'une période de prestations, un livret de congés pour chacun de ses salariés; 2) exiger de tout salarié embauché au cours d'une période de prestations, le ramise de son Boiler fireman, required to hold a 4th class certificate.1.00 Water carrier.0.80 Men committed to the ramming, smoothing and spreading of asphalt.0.90 Men committed to the piping, caulkers and welders.0.90 2.Subsection \"b\" of section IV is replaced by the following: b) Travelling expenses of employees sent outside the City of St.John and the Town of Iberville shall be paid by the employer without wage deduction.Besides, the noon meal shall be paid by the employer if the employee has not been notified the day before.Board shall also be paid by the employer when the employees are not taken back every night in the said city and town.\" 3.Subsection \"e\" of section VI is deleted: 4.The following section XI-A is added: \"XI-A.Vacation with pay: a) Definitions : Barring incompatibility, the following words have the meaning hereinafter given to them: Employer : Any person hiring an employee governed by the present decree; Commissio7i : The Minimum Wage Commission ; Vacation-with-pay stamps book: A book issued by the Commission for the purpose of affixing therein, during a vacation-with -pay credit period vacation-with-pay credit stamps; Vacation-with-pay credit period : The period extending from the 1st of May of one year to the 30th of April of the next year; Vacation-with-pay credit stamps : The printed mark or stamp issued by the Commission, representing the vacation-with-pay credit payable by an employer; b) Rights of the employee : 1.to a vacation-with-pay : Every employee governed by the present decree, whose work has been continuous with one employer throughout a vacation-with-pay credit period, is entitled, at the end of such period, to a vacation having a minimum duration of seven consecutive days and to the vacation credit hereinafter determined; 2.to a vacation credit: Every employee governed by the present decree, whose work has not been continuous with one employer thoughout a vacation-with-pay credit period, is entitled, at the end of such period, only to the vacation credit hereinafter determined.c) Period during which vacation is to be given: The employer must give, whithin four months from the date of expiration of a vacation-with-pay credit period, the vacation to which an employee is entiled according to the present section.d) Vacation credit: The vacation credit to which an employee governed by the decree is entitled represents, for a vacation-with-pay credit period, a sum of money equivalent to the face value of the stamps affixed in his vacation-with-pay stamp book, for said credit period.e) Affixing of stamps : Every employer, at the end of each regular pay period, must affix in his employee's vacation-with-pay stamp book vacation-with-pay credit stamps in an amount equivalent to two per centum (2%) of the gross amount of such pay./) Emploijcrs obligations: Every employer must 1) obtain from the Commission a vacation-with-pay stamp book for each of his employees, before the beginning of a vacation-with-pay credit period; 2) require from every employee hired during a vacation-with-pay credit period, the remittance 1398 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1961, Tome 83, N° 18 livret de congés et, s'il n'en possède pas, lui en procurer un; 3) conserver jusqu'à la fin d'une période de prestations ou, s'il y a résiliation antérieure du contrat de travail, durant le temps d'emploi, les livrets de congés de chacun de ses salariés; 4) remettre à chacun de ses salariés à la fin d'une période de prestations ou lors de la résiliation antérieure de son contrat de travail, son livret de congés.L'employeur qui fournit à un salarié un livret de congés payés peut en déduire le coût du salaire de ce dernier.g) Obligations du salarié: Tout salarié doit: 1) remettre sans délai son livret de congés à l'employeur qui l'engage au cours d'une période de prestations ; 2) réclamer de l'employeur qui l'emploie, son livret de congés à la fin d'une période de prestations ou lors de la résiliation antérieure de son contrat de travail.h) Remboursement de la rémunération : Tout salarié a le droit de réclamer de la Commission, à la fin d'une période de prestations, le remboursement des timbres apposés dans son livret de congés pour telle période.i) Propriété du livret de congés payés : Le livret de congés payés, bien qu'il puisse être en la possession de l'employeur, est la propriété du salarié; la créance qu'il constate est incessible.j) Convention interdite: Est expressément interdite toute stipulation d'un contrat accordant à un salarié régi par le présent décret, des conditions moins avantageuses que celles fixées au présent article.k) Entrée en vigueur : Le présent article entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté en conseil dans la Gazette officielle de Québec, et jusqu'au 1er mai 1952, le terme \"période de prestations\" dans le présent article, désigne la période s'étendant de ce jour au 1er mai 1952.\" 5° Le paragraphe \"k\" de l'article XII est remplacé par le suivant: \"k) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux apprentis des métiers ci-après mentionnés: Taux horaires 1.Charpentier-menusiier, peintre, asper-geur, vitrier, décorateur, tapissier et vernisseur: 1ère année.$0.75 2ème année.0.80 3ème année.0.85 4ème année.0.95 2.Électricien, plombier, poseur d'appareils de chauffage, mécanicien en tuyauterie, soudeur en tuyauterie, ouvrier-tôlier et ferblantier-couvreur: 1ère année.0.75 2ème année.0.85 3ème année.0.90 4ème année.0.95 3.Briqueteur, maçon, plâtrier: 1ère année.0.95 2ème année.1.00 3ème année.1-05 4ème année.1.20 4.Poseur de brûleurs à l'huile: 1ère année.0.85 2ème année.0.95\" 6° L'article XIV est remplacé par le suivant: \"XIV.Durée du décret : Le présent décret est valable à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec, et demeure en of his vacation-with-pay stamp book and, should he not possess such book, provide him with one; 3) keep each employee's vacation-with-pay stamp book till the end of the vacation-with-pay credit period, or, during the time of employment, should the employee's labour contract be previously cancelled; 4) give back his vacation-with-pay stamp book to each one of his employees, at the end of a vacation-with-pay credit period or at the time, of the previous cancellation of his labour contract.The employer who provides his employee with a vacation-with-pay stamp book may deduct from the employee's wages the cost of such book.g) Employee's obligations : Every employee must 1) without delay, give back his vacation-with-pay stamp book to the employer who hires him during a vacation-with-pay period; 2) at the end of a vacation-with-pay credit period or at the time of the previous cancellation of his labour contract, claim his vacation-with-pay stamp book from the employer who hires him.h) Redemption of stamps : Every employer at the end of a vacation-with-pay credit period, has the right to claim from the Commission the redemption of the stamps affixed for such period in his vacation-with-pay stamp book.i) Ownership of the vacation-with-pay stamp book : Though in the employers' hands, the vacation-with-pay stamp book belongs to the employee, and the credit shown therein is untransferable.j) Forbidden agreement : Any stipulation of a labour contract for the purpose of granting to an employee governed by the decree, conditions less advantageous than those fixed in the present section is strictly forbidden.k) Date of enforcement : The present section comes into force on the day of the publication of the present Order-in-Council in the Quebec Official Gazette and remains effective until May 1, 1952, The words \"vacation-with-pay credit period\" mentioned in the present section mean the period extending from that day to May 1, 1952.\" 5.Subsection \"k\" of section XII is replaced by the following: \"k) The following minimum wage rates shall be paid to apprentices of the trades hereafter mentioned: Hourly rates 1.Carpenter-joiner, painter, sprinkler fitter, glazier, decorator, paper hanger and varnisher: 1st year.0.75 2,ndyear.0.80 3rd year.0.85 4th year.'.0.95 2.Electrician, plumber, steamfitter, pipe mechanic, pipe welder, sheet-metal worker and tinsmith-roofer: 1st year.0.75 2nd year.0.85 3rd year.0.90 4th year.0.95 3.Bricklayer, mason, plasterer: 1st year.,.0.95 2nd year.1.00 3rd year.1.05 4th year.1.20 4.Oil burner fitter: 1st year.0.85 2nd year.0.95\" 6.Section XTV is replaced by the following: \"XIV.Duration of the decree: The present decree comes into force the day of its publi- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol 83, No.18 1399 vigueur jusqu'au 30 avril 1952.Il se renouvelle cation in the Quebec Official Gazette and remains automatiquement d'année en année, par la suite in force until April 30, 1952, It then renews à moins que l'une des parties contractantes, ne itself automatically, from year to year, unless donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, one of the contracting parties notify the other dans un délai qui ne doit pas être de plus de soi- party, in writing, to the contrary within the xante (60) ni de moins de trente (30) jours avant period extending from the 60th to the 30th day le 30 avril de chaque année.Un tel avis doit before April 30 of each year.Such a notice également être adressé au Ministre du Travail.\" must also be sent to the Minister of Labour.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) (Document \"A\" annexed to the order) A.MOPJSSET,.A.MORISSET, 30058-o Greffier du Conseil Exécutif.30058-o Clerk of the Executive Council.'Avis divers Miscellaneous Notices Avis est donné que, sur recommandation de Notice is hereby given that, upon the recom- l'Assistant-procurcur général, l'Honorable Secré- mendation of the Deputy Attorney General, the taire de la Province a approuvé, en date du 26 amendments to articles 22 and 23 of the By-laws avril, 1951, les amendements aux articles 22 et 23 of \"The Beach Club, Incorporated\", as adopted des règlements de \"The Beach Club, Incorpo- at the special general meeting held on July 20th, rated\", tels qu'adoptés à l'assemblée générale 1949, were approved by the Honourable the spéciale tenue le 20 juillet 1949, et ce, conformé- Provincial Secretary on April 26th, 1951, pur- ment aux dispositions de l'article 225 de la Loi suant to the provisions of section 225 of the des compagnies de Québec (R.S.Q.1941, cha- Quebec Companies Act (R.S.Q.1941, chapter pitre 276).276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, Given at the office of the Provincial Secretary, le 28 avril 1951.this 28th day of April, 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 30029 JEAN BRUCHÉSI.30029-o Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de St-Dominique de Bagot\", en date du 12 mars 1951, dont le siège social est situé à Saint-Dominique, comté de Bagot, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 10 avril 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30030-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de St-Dominique de Bagot\", under date the twelfth day of March, 1951, whereof the head office is at Saint-Dominique, county of Bagot, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this tenth day of April, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30030 Under Secretary of the Province.Avis de changement de nom Notice of Change op Name (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicates' Act) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Notice is hereby .given that the'Honourable the Province a autorisé, le 20 avril 1951, le change- Provincial Secretary, on April 20th, 1951, au- ment de nom de \"Le Syndicat Catholique et Na- thorized the change of name of \"Le Syndicat Ca- tional des Employés de Magasin (SD)\" en celui tholique et National des Employés de Maga- de \"Le Syndicat National des Employés du Com- sin (SD)\" into that of \"Le Syndicat National des merce de Montréal\", et ce, conformément aux Employés du Commerce de Montréal\", and such, dispositions des articles 7 et suivants de la Loi pursuant to the provisions of sections 7 and fol- des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, cha- lowing of the Professional Syndicates' Act, R.S.pitre 162.Q., 1941, chapter 162.Donné au bureau du Secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary, le 21 avril 1951.this 21st day of April, 1951.Le Sous-secrétaire de la Province,' JEAN BRUCHÉSI, 30031-o JEAN BRUCHÉSI.30031 Under Secretary of the Province.Société Saint-Jean Baptiste de la région Société Saint-Jean Baptiste de la région des Troïs-Rivières Incorporée des Trois-Rivières Incorporée Extrait des règlements de la société ci-haut Excerpt from the By-laws of the above men- mentionnée concernant l'augmentation du nom- tioned society concerning the increase of the bre de ses directeurs de trois à vingt-cinq: number of its directors from three to twenty-five.\"Le Bureau des directeurs se compose de \"The Board of Directors will be composed of vingt-cinq (25) membres choisis par et parmi les twenty-five (25) members, chosen by and among délégués à l'assemblée générale annuelle.\" the delegates at the annual general meeting.\" Pour copie conforme.True ccpy.Chef du Secrétariat, JEAN PELLERIN, 30034-o JEAN PELLERIN.3C034 Chief Secretary. 1400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Vome 83, N° 18 Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le 28 février 1950, le changement de nom de \"La Fédération Nationale Catholique des Services Hospitaliers et Institutions Religieuses Inc.\", en celui de \"La Fédération Nationale Catholique des Services, Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles que modifiées par 10, George VI, chapitre 20, article 3.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 3 avril 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30033-o JEAN BRUCHÉSI.Notice of Change of Name (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized under date the 28th day of February, 1950, the change of name of \"La Fédération Nationale Catholique des Services Hospitaliers et Institutions Religieuses Inc.\", into that of \"La Fédération Nationale Catholique des Services, Inc.\", pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as amended by 10 George VI, chapter 20, section 3.Given at the office of the Provincial Secretary, this third day of April, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30033 Under Secretary of the Province.John Watson & Company Limited Sommaire du règlement N° 4 des règlements de la compagnie.Il a été décrété que les affaires de la compagnie soient liquidées, que toutes ses obligations soient protégées et que son actif soit distribué entre les actionnaires et que la compagnie demande au Procureur général la permission d'abandonner sa charte.Passé en la cité de Montréal, le 12 janvier 1951.[Sceau] Le Secrétaire, 30037 (Mme) Ethel A.Carruthers.John Watson & Company Limited Summary of by-law No.4 of the Company's by-laws.It was enacted that the affairs of the company be wound up, all its liabilities be satisfied and its assets be distributed among the shareholders, and that the company apply to the Attorney General for leave to surrender its charter.Passed at the city of Montreal, on the 12th day of January, 1951.[Seal] (Mrs) Ethel A.Carruthers, 30037-o Secretary.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le vingt-six avril 1951, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Le Syndicat National des Chantiers Maritimes de Sorel\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 27 avril 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30044-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of April twenty-sixth, 1951, enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Le Syndicat National des Chantiers Maritimes de Sorel\", and such, pursuant to the \"provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th of April, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30044 Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Les Instituteurs du Sud\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, soiaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-huit avril 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Richmond, comté de Richmond.Le Sous-secrétaire de la Province, 30049-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Les Instituteurs du Sud\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on April 28, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Richmond, county of Richmond.JEAN BRUCHÉSI, 30049 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative d'Habitation Les Chantiers Saint-Esprit\", en date du 3 avril 1951, dont le siège social est situé à Valleyfield, comté de Beauharnois, et que ce doument Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Coopérative d'Habitation Les Chantiers Saint-Esprit\" under date the 3rd day of April, 1951, whereof the head office is at Valleyfield, county of Beau- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol 83, No.18 1401 a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 20 avril 1951.Le Sous-secrétaire de la province.30056-o JEAN BRUCHÉSI.Samuels & Company Limited Un règlement pour augmenter le nombre de directeur de la compagnie ci-dessus de trois à cinq.Règlement N° 11 \"11.Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction de cinq directeurs.\" La Secretaire, 30050-o SARA SAMUELS.harnois, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary this twentieth day of April, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30056 Under Secretary of the Province.Samuels & Company Limited By-Law increasing the number of Directors of the above company from three to five.By-law number 11 \"11.The affairs of the Company shall be managed by a Board of Five Directors.\" SARA SAMUELS, 30050-o Secretary.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association Indépendante des Employés de Century Leather Goods\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le premier mai 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la Province, 30061-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association Indépendante des Employés de Century Leather Goods\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on May 1st, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI, 30061 Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association des Employés de Regent Knitting\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le premier mai 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Jérôme, comté de Terre-bonne.Le Sous-secrétaire de la Province, 30062-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association des Employés de Regent Knitting\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 1st, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Jérôme, county of Terrebonne.JEAN BRUCHÉSI, 30062 Under Secretary of the Province.Avis est parles présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif des Produits Agricoles de St-Gédéon', en date du 5 avril 1951, dont le siège social est situé à Saint-Gédéon, comté de Lae St-Jean, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 25 avril 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30067-Q JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif des Produits Agricoles de St-Gédéon\", under date the 5th day of April, 1951.whereof the head office is at Saint-Gédéon, county of Lake St.John, and that the said document has been filed in the archives of the department of Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of April, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30067 Under Secretary of the Province. 1402 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome 83, N° 18 La Companie Santerre Limitée AVIS La Compagnie ci-dessous a adopté et fait approuver régulièrement un règlement pour la distribution à ses actionnaires de tout son actif conformément à l'article 90 de la Loi des Compagnies de Québec.Riraouski, le 1er mai 1951.Le Secrétaire, 30072-o R.-O.GILBERT.La Compagnie Santerre Limitée NOTICE \u2014 * The above company has adopted and caused to be regularly approved, a By-law for the distribution to its shareholders of the Avhole of its assets, in conformity with section 90 of the Quebec Companies' Act.Rimouski, May 1, 1951.R.0.GILBERT, 30072 Secretary.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Heward Production Co.Limited Avis est donné que la compagnie \"Heward Production Co.Limited\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, a l'intention de demander au Procureur général le permission d'abandonner sa charte.Heward Production Co.Limited, Le Secrétaire-trésorier, 30036 W.J.COCHRANE.John Watson & Company Limited Avis est donné que la compagnie \"John Watson & Company Limited\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, le 26 avril 1951.(Sceau) Le Secrétaire, 30038 (Mme) ETHEL A.CARRUTHERS.AVIS Heward Production Co.Limited Notice is hereby given that \"Heward Production Co.Limited\", incorporated under the Quebec Companies Act, intends to apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter.Heward Production Co.Limited, W.J.COCHRANE, 30036-o Secretary-Treasurer.John Watson & Company Limited Notice is hereby given that \"John Watson & Company Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal this 26th day of April 1951.(Seal) (Mrs) ETHEL A.CARRUTHERS, 30038-o Secretary.NOTICE Wilfrid Gauvreau Ltée donne par les présentes Wilfrid Gauvreau Ltée hereby gives notice avis qu'elle demandera la permission d'aban- that it will make application for leave to surrender donner sa charte conformément à la Loi des its charter under the Quebec Companies Act.Compagnies de Québec.Le Secrétaire, LAURENT DROUIN, 30047-o LAURENT DROUIN.30047-o Secretary.Siscoe Metals Limited AVIS Conformément aux dispositions de la loi des Compagnies de Québec, Siscoe Metals Limited, donne par les présentes avis public qu'elle demandera la permission d'abandonner sa charte et de faire fixer une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Montréal, le 30 avril 1951.Le Secrétaire, 30048-o CLINTON M.MASTERMAN.M.& M.Realties Corporation Avis est par ces présentes donné que M.& M.Realties Corporation a l'intention de faire application au Procureur général de la Province de Québec pour abandon de sa charte» Daté ce 12 avril, 1951.Le Secrétaire, 30066-o Mrs.M.BLOOMFIELD.Siscoe Metals Limited NOTICE .Under the provisions of the Quebec Companies' Act Siscoe Metals Limited hereby gives Notice that it will make application for the acceptance of surrender of its Charter and to fix a date upon and from which the Company shall be dissolved.Montreal, April 30th, 1951.CLINTON M.MASTERMAN, 30048-o Secretary.M.& M.Realties Corporation Notice is hereby given under the Quebec Companies Act and amendments that M.& M.Realties Corporation intends to apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Dated this 12th day of April, 1951.Mrs.M.BLOOMEffiLD, 30066-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1961, Vol.88, No.18 1403 Commission du Salaire Minimum Commission du Salaire Minimum RÉSOLUTION La Commission du salaire minimum a adopté à sa séance du 25 avril 1951, la résolution suivante: Ordonnance N° 51 \u2014 alimentation en gros : La Commission, vu l'article 21 de son Statut et la recommendation qui lui a été faite par l'honorable ministre du Travail «à la suite de représentations de groupes d'employeurs, décide de suspendre totalement pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à compter de la publication dans la Gazette officielle de la présente résolution, l'application de son ordonnance N° 51 qui a été publiée dans la Gazette officielle du 14 avril 1951 et qui entrait en vigueur à cette date.Québec, 25 avril 1951.Commission du Salaire Miminum (Sceau) Le Président, (Signé) F.-X.LACOURSIÈRE, Le Secrétaire général, (Signé) PHILIPPE ROUSSEAU, c.r., Copie conforme Le Secrétaire général et conseiller juridique PHILIPPE ROUSSEAU, c.r.30054-o Commission Municipale de Québec La Commission Municipale de Québec Avis d'échange d'obligations Loi pour assurer le progrès de l'éducation (10 Geo.VI, ch.21\u201411 Geo.VI, ch.32) Avis est, par les présentes, donné que, conformément aux dispositions de la Loi pour assurer le progrès de l'éducation (10 George VI, chapitre 21, tel que modifié par 11 George VI, chapitre 32), la commission scolaire ci-dessous mentionnée s'est prévalue de ladite loi ; Que, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la dite loi, la Commission municipale de Québec a préparé la réorganisation financière comportant le règlement des dettes de la dite commission scolaire (savoir les emprunts contractés avant le 17 avril 1946) et cette réorganisation a dûment été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil (O.C.N° 431 du 26 avril 1951); Que, conformément aux dispositions dudit ordre en conseil numéro 431 du 26 avril 1951, les détenteurs des obligations ci-dessous énu-mérées sont priés de transmettre, le ou après le 1er juin 1951, les dites obligations à toutes succursales dans la Province de Québec de la Banque Canadienne Nationale, de la Banque de Montréal, de la Banque Royale du Canada, de la Banque Canadienne de Commerce ou de la Banque Provinciale du Canada, ou à leur bureau chef dans les cités de Toronto, Winnipeg ou Vancouver, pour être transmises au bureau chef de la Banque Canadienne Nationale qui fera l'échange pour des obligations de la Commission municipale de Québec.Les coupons Minimum Wage Commission Minimum Wage Commission RESOLUTION The Minimum Wage Commission has at it's sitting of the 25th April 1951, adopted the following resolution: Ordinance No.51 \u2014 Wholesale Foodstuffs: Pursuant to section 21 of the Minimum Wage Act, and because of the recommendation made by the Honourable Minister of Labour to the Commission following the representations of groups of employers, the Commission decides to suspend totally for a period not exceeding three (3) months computed from the publication in the Quebec Official Gazette of the present resolution; the application of its Ortinance No.51 which was published in the Quebec Official Gazette of April 14, 1951, and entered into force on that date.Quebec, April 25, 1951.Minimum Wage Commission (Seal) (Signed) F.X.LACOURSIÈRE, President.(Signed) PHILIPPE ROUSSEAU, c.r.Secretary-\"General.True copy PHILIPPE ROUSSEAU, Secretary-General Legal advisor 30054-o Quebec Municipal Commission Quebec Municipal Commission Notice of Exchange of Debentures Act to ensure the Progress of Education (10 Geo.VI, Chap.21 ; 11 Geo.VI, Chap.32) Notice is, hereby given that in conformity with the provisions of the Act to ensure the Progress of Education (10 George VI, Chapter 21, as amended by 11 George VI, chapter 32), the school commission hereunder named has availed itself of the said law; That, in compliance with Sections 7 and 8 of the said Act, the Quebec Municipal Commission has prepared a financial reorganization of the debts of the said school commission (i.e.loans contracted prior to the 17th of April 1946) and this reorganization has duly been approved by the Lieutenant-Governor in Council (O.C.No.431 of the 26th of April 1951); That, in compliance with the provisions of said Order in Council No.431 of the 26th of April 1951, all holders of bonds or debentures hereunder listed are requested to forward, on or after the 1st of June 1951, their bonds or debentures to all branches in the Province of Quebec of the Banque Canadienne Nationale, or of the Bank of Montreal, or of the Royal Bank of Canada, or of The Canadian Bank of Commerce, or of The Provincial Bank of Canada, or at their principal office in the cities of Toronto Winnipeg or Vancouver, to be forwarded to the Head Office of the Banque Canadienne Nationale which will effect the exchange for bonds of the Quebec Municipal Commission.The interest 1404 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1951, Tome S3, N\" 18 d'intérêt échéant après le 1er juillet 1951 devront être attachés aux obligations transmises pour échange.Ces obligations tresseront de porter intérêt à compter du 1er juin 1951.Commission scolaire dont les obligations seront échangées: St-Hilairc & St-Jcan Baptiste, (Comté de Rouville), syndics, protestants: Emission 87,-500.00, datée du 1er juillet 1942, 4%.Obligations échéant du 1er juillet 1951, au 1er juillet 1957 inclusivement.Daté à Québec ce premier jour de mai 1951.La Commission Municipale de Québec, par le Secrétaire, 30069-o MAURICE R.MARCOTTE.coupons maturing after the 1st of July 1951 shall be attached to the bonds or debentures remitted for exchange.These bonds or debentures shall cease to bear interest as of the 1st of June 1951.School Commission whose bonds or debentures will be exchanged: St.Hilaire & St.Jean Baptiste, (County of Rouville) Trustees, Protestant: Issue $7,500.00 dated July 1, 1912, 4%\u2014Bonds or debentures maturing from July 1, 1951 to July 1, 1957 inclusive.Dated at Quebec, this first day of May 1951.The Quebec Municipal Commission, per: MAURICE R.MARCOTTE.30009-o Secretary.Département des Affaires Municipales Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 2 avril 1951 du conseil de la paroisse de la Visitation de la Pointe du Lac, comté de St-Maurice, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a décrété, en date du 26 avril 1951, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporatoin, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se fassent, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en conformité tie l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 26 avril 1951.\" Le Ministre des Affaires municipales.30045-o BONA DUSSAULT.Department of Municipal Affairs The undersigned, gives notice, that as requested by a resolution of April 2, 1951, of the Council of the parish of \"La Visitation de la Pointe du Lac\", county of St-Maurice, and pursuant to the provisions of article 130 of the Municipal Code, lie has enacted under date of April 26, 1951, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders, of the said corporation with the exception of those required in the Quebec Official Gazette, be made, in future, in the French language only.The present notice is published in conformity with article 131 of the Municipal Code, (10 George VI, chapter 55, section 2).Quebec, April 20, 1951.BONA DUSSAULT, 30045 Minister of Municipal Affairs.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne division d'enregistrement de Montréal.(Partie de la ville de Ste-Anne-de-Bellevue) Avis est pai la présente donné que le lot 339 (île) est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD, Québec, le 28 maïs 1951.30046-o Sous-Ministre.Département du Travail Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the Parish of Ste.Anne registration division of Montreal.(Part of the Town of Ste.Anne-de-Bellevue) Notice is hereby given that lot 339 (Island) is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Department of Lands and Forests Cadastral Branch, AVI LA BÉDARD, Quebec, March the 28th, 1951.30046-o Deputy Minister.Department of Labour AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire de l'Industrie du Lait de Québec, établi en exécution du décret numéro 481, du 5 mai 1949, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 455 du 26 avril 1951, section \"C\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of the Milk Industry of Quebec, formed under decree number 481 of May 5th.1949, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 455 of April 20.1951, part \"C\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1951, Vol.83, No.18 1405 artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle île Québec, au premier mars 1952; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Tous les employeurs professionnels de l'Industrie du Lait assujettis audit décret numéro 4SI, doivent payer au Comité paritaire une somme équivalente à Yl de 1% de la liste des salaires qu'ils versent à leurs employés régis par ledit décret.b) Tous les artisans assujettis audit décret doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yl de 1% du salaire établi dans le décret pour le salarié le moins rémunéré dans leur occupation.c) Tous les salariés de l'industrie du Lait, régis par ledit décret numéro 4SI, doivent verser au Comité paritaire une cotisation équivalente à Yl de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception L'employeur professionnel et l'artisan doivent faire parvenir leurs cotisations mensuellement au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit percevoir les cotisations de ses salariés à même le salaire qu'il est tenu de leur payer et en faire remise au Comité paritaire en même temps que sa propre cotisation.Sur refus d'un employeur de payer ses cotisa-lions ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq jour lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rap port ft nanc icr D'accord avec l'article 21 de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux périodes fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie du Lait de Québec, pour la période comprise entre le 1er mars 1951 et le 1er mars 1952.Le Comité paritaire de l'Industrie du lait de Québec Estimé des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er mars 1951 et le 1er mars 1952.Recettes: Cotisations (Yl de 1%): Employeurs professionnels.$4,000.00 Salariés.4,000.00 Artisans.300.00 $8,300.00 Déboursés: Loyer du bureau.S 360.00 Salaire du secrétaire-trésorier.2,300.00 Salaire de l'inspecteur.2,600.00 Frais d'inspection.600.00 Sténographe.900.00 Frais légaux.200.00 Vérification.80.00 Papeterie et fournitures.300.00 Timbres.100.00 Frais de déplacement.500.00 said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned : 1.Assessments The period of levy extends from the date of publication of the present by-law in the Quebec Official Gazette to the 1st of March, 1952, and is laid in the following manner; a) The professional employers of the milk industry governed by the said decree, No.481, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y °f 1% of the wages paid to their employees governed by the decree.b) All artisans governed by the said decree shall pay to the Parity-Committee a sum equivalent to 3^ of 1% of the lowest wages established in the decree for an employee of the same occupation.c) The employees of the milk industry, governed by the said decree No.481, shall pay to the Parity Committee an assessment equivalent to Yi of 1% of their wages.2.Mode of collection The professional employer and the artisan shall send their assessments every month to the Parity Committee.«\u2022\u2022 The professional employer shall collect the assessments of his employees from the wages paid to them and remit same to the Parity Com-mitte together with his own assessments.Should an employer refuse to pay or to give the necessary information, he will be given 5 days notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to section 21 of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report of its financial operations and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of the Milk Industrv of Quebec for the period between March 1, 1951, ami March 1.1952.Parity Committee of the Milk Industry of Quebec Estimate of the receipts and disbursements for the priod between March 1, 1951, and March 1, 1952.Probable receipts: Assessments (Y of 1%): Professional emplovers.84,000.00 Employees.4,000.00 Artisans.300.00 88,300.00 Probable expenses: Rent.S 360.00 Salary of Secretary-Treasurer.2,300.00 Salary of the Inspector.2,600.00 Inspection expenses.600.00 Stenographer.900.00 Legal fees.200.00 Audition.80.00 Stationery.300.00 Stamps.100.00 Travelling expenses.500.00 > 1400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec,.B mai 1951, Tome 83, N° 18 Dépenses non prévues.360.00 Unforeseen and general expenses.300.00 S8.300.00 88,300.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 5 mai 1951.\" 30059-o Quebec, May 5, 1951.30059-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective ((S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la peinture dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 1402 du 4 août 1948, lui ont présenté une requête à l'effet, d'amender ledit décret, dans sa teneur modifié de la façon suivante: 1 ° L'article IV sera remplacé par le suivant: \"IV.Taux de salaires: Les taux minima de salaires sont les suivant s: NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the paint industry in the province of Quebec, rendered obligatory by the decree number 1402 of August 4, 1948, have submitted to him a request ot amend the said decree, as amended, as follows: i 1.Section IV will be replaced by the following: \"IV.Rates of wages: The minimum rates of wages arc the following: Occupations: Taux horaires Occupation : Fabrique de peinture cl de laque: minima Paint and Lacquer Factory : a) Journalier.80.90 1.b) Aide.-.;.0.95 c) Remplisseur.0.98 d) Préparateur de couleurs.1.05 e) Broyeur de couleurs, 2èmc classe.1.00 \" /) Broyeur de couleurs, 1ère classe.1.10 g) Coloriste, 2èmc classe.1.08 h) Coloriste, 1ère classe.1.12 1.Fabrique de vernis: 2.a) Journalier.b) Aide.c) Remplisseur.d) Préposé au diluant.e) Préposé aux bouilloires, 2ème classe./) Préposé aux bouilloires, 1ère classe.Fabrique de blanc de plomb et de couleur sèche: 3.a) Journalier.b) Aide.c) Broyeur, 2èmc classe.d) Broyeur, 1ère classe.e) Préposé aux presses, 2ème classe./) Préposé aux presses, 1ère classe.g) Préposé à la fabrication de la pein- ture, 2ème classe.;.h) Préposé à la fabrication de la peinture, 1ère classe.Réception, emballage et expédition: 4.a) Journalier.b) Aide.c) Emballeur.- d) Commis préposé à l'expédition et gardien du stock.Général: 5.a) Gardien, chauffeur, pointeur, (par semaine).b) Tonnelier et apprêteur.c) Préposés à l'entretien, y compris les charpentiers, les électriciens, les plombiers, les machinistes et les forgerons.d) Mécanicien de machine fixe, 4ème classe.;.e) Mécanicien de machine fixe, 3ème classe./)Mécanicien de machine fixe, 2ème classe.6.a) Salarié de sexe masculin de mois de 18 ans.0.90 0.95 0.98 1.00 1.10 1.16 0.90 0.95 1.02 1.07 1.02 1.06 2.3.Minimum Hourly rates a) Labourer.80.90 b) Helper.0.95 c) Filler.0.98 d) Mixer.1.05 e) Millman, 2nd class.1.06 /) Millman, 1st class.1.10 g) Shader, 2nd class.1.08 «) Shader, 1st class.1.12 Varnish Factory : a) Labourer.0.90 b) Helper.\u2022.0.95 c) Filler.0.98 d) Thinner man.1.06 c) Kettleman, 2nd class.1.10 /) Kettleman, 1st class.1.16 White Lead and Dry Colour Factory : a) Labourer.0.90 b) Helper.0.95 c) Grinder, 2nd class.1.02 d) Grinder, 1st class.1.07 e) Pressman, 2nd class.1.02 /) Pressman, 1st class.1.06 1.07 g) Striker, 2nd class.10.7 1.10 0.90 0.96 0.98 0.98 46.75 0.98 1.18 1.03 1.12 h) Striker, 1st class.1.10 Receiving, Packing and Shipping Departments: 4.a) Labourer.0.90 b) Helper.0.96 c) Packer.0.98 d) Shipping clerk and stockkeeping clerk.0.98 General : 5.a) Watchman, Fireman, Timekeeper (per week).44.76 b) Cooper and mill dresser.0.98 c) Maintenance man, including carp- enter, electrician, plumber, machinist and blacksmith.1.18 d) Stationary Engineman, 4th class .1.03 e) Stationary Engineman, 3rd class .1.12 1.25 /) Stationary Engineman, 2nd class.1.25 6.a) Male employees (under 18 years of 0.66 age).0.66 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol.83, No.18 1407 /;) Salarié du sexe masculin de 18 ans ou plus.0.90 7.Garçons de moins de 18 ans ou plus.0.66 Il ne doit pas y avoir plus d'un gar -on pour 8 salariés dans chaque établissement.Salariées 8.a) Aides.0.66 b) Étiquetteuses.0.72 c) Opératrice et remplisscuses.0.77 Huile de lin; 9.a) Journalier.0.90 b) Préposé aux presses hydrauliques et aux machines à expulsion.0.98 c) Préposé à l'entretien.1.18 10.Chefs d'équipe: Les chefs d'équipe doivent recevoir $0.05 de plus l'heure que le taux minimum déterminé dans le présent décret pour leur classification.\" 2° L'article X-A sera remplacé par le suivant: \"X-A.Jour de fête payés: Les salariés doivent être rémunérés pour les six jours de fête chômés suivants: Le Premier de l'An, la Fête du Travail, le jour de Noël, le Vendredi Saint, la Confédération et le jour d'Action de Giaccs a condition qu'ils travaillent le premier jour ouvrable suivant ces dites fêtes, à moins d'empêchement par la maladie.La rémunération doit être vasée sur la journée régulière de travail de chaque salarié, exception faite du travail supplémentaire.Tout salarié qui travaillent un des jours ci-haut mentionnés doit, en plus être rémunéré au taux régulier de salaire pour les heures de travail effectuées.Toutefois, il sera permis à la discrétion de l'employeur et des salariés d'un établissement, de remplacer la Confédération par la St.Jean Baptiste.La Confédération deviendra alors un jour normal de travail et la St.Jean Baptiste un jour de fête chômé et payé.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travai recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministre du Travail, Québec, le 5 mai 1951.30060-o b) Male employees (18 years of age or more).0.90 7.Boys under 18 years of age.0.66 The number of boys shall not exceed one to every eight employees in each plant.Female employees : 8.a) Helpers.0.66 b) Labellers.0.72 c) Operators and fillers.0.77 Lindsccd Oil Mill : 9.a) Labourer.0.90 b) Hudraulic press or expeller man.0.98 c) Maintenance man.1.18 10.Charge Hands: Charge Hands shall be paid 80.05 cts.per hour more than the minimum rate determined in this decree for their classification.\" .2.Section X-A will be replaced by the following: \"X-A.Statutory Holidays with pay : Employees shall be paid for the following six (6) observed holidays: New Year's Day, Labour Day, Christmas Day, Good Friday, Dominion Day, Thanksgiving Day, provided they work the first working day following these said holidays unless prevented from so doing by sickness.Remuneration shall be based upon the regular working day of each employee, excluding overtime.An employee who works on any of the above days shall, in addition, be paid at his regular hourly rate for the hours worked.However, at the option of the employers and employees of any establishment, it shall be per-missable to substitute St.John Baptist Day for Dominion Day, in which event, Dominion Day would become a normal working day and St.John Baptist a holiday with pay.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 5, 1951.30060-o AVIS DE MODIFICATION.NOTICE OF AMENDEMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister Travail, donne avis par les présentes, conformé- of Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Loi de la convention provisions of the Collective Agreement Act collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amende- (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that ments), que les parties contractantes à la conven- the contracting parties to the collective labour tion collective de travail relative à l'industrie et agreement relating to the construction industry aux métiers' de la construction dans la région de and trades in the district of Montreal, rendered Montréal, rendue obligatoire par le décret nu- obligatory by the decree number 407 of April 12, méro 407 du 12 avril 1950, lui ont présenté une 1950, have submitted to him a request to amend requête à l'effet d'amander ledit décret, dans sa the said decree, as amended, as follows: teneur modifié, de la façon suivante: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article I sera rem- 1.Subsection \"a\" of section I will.be replaced placé par le suivant: by the following: \"a) L'Ile de Montréal et quinze (15) milles de \"a) The Island of Montreal and fifteen miles son périmètre par le chemin le plus court.\" from its perimeter by the shortest road.\" 2° Les taux de salaires pour les métiers ci- 2.The wage rates for the trades hereafter après mentionnés, apparaissant à l'article HI, mentioned, contained in section HI-a, will be paragraphe \"a\", seront remplacés par les sui- replaced by the following: vants: \"Métiers \u2014 Trades: Taux horaires Wage rates per hour Mécanicien en isolement d'amiante \u2014 Asbestos insulation mechanic.$ 1.57 Briqueteur et poseur de blocs de ciment \u2014 Bricklayer and cement block layer.1.72 Calfat \u2014Caulker.1.07 1408 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1951, Tome 88, N° 18 Charpentier, menuisier, mécanicien (y compris les opérations suivantes: formes à béton (boutique ou chantier), ppsage de paravents (bois ou métal), châssis, fenêtres, \"weatherstrips\", bardeaux revêtements de murs, bois ou composition, divisions en acier et d'ameublement, tels que comptoirs et tablettes (fixes ou mobiles) \u2014 Carpenter, joiner and millwrights and including the following operations: concrete forms (yard or job), the erection of screens (wood or metal), sashes, windows, weatherstrips and shingles, siding, wood or composition, steel partitions and equipment, such as counters ami shelving, moveable or immoveable.Finisseur de ciment \u2014 Cement finisher.Poseur d'acier d'armature de béton \u2014 Concrete reinforcing steel erector.Poseur de liège isolateur \u2014 Cork insulation setter.Électricien-compagnon \u2014 Electrician-journeyman.Préposé aux grues \u2014 Engineman (hoisting).Préposé aux malaxeurs à vapeur \u2014 Engineman (steam mixers).Préposé aux malaxeurs à gazoline \u2014 Engineman (gas mixers).Préposé aux compresseurs \u2014 Engineman (compressor).Chauffeur (construction) \u2014 Fireman (construction).Porteur d'oiseau \u2014 Hod carrier.Journalier (ouvrier non-qualifié) \u2014 Labourer (common).Contremaître jardinier-paysagiste \u2014 Landscape foreman.Jardinier-paysagiste (non-qualifié) \u2014 Landscape workman (common).Poseur de lattes en bois ou en tout autre matériel) \u2014 Lather (wood antl all other material) Poseur de linoleum, tie muroleum ou tie caoutchouc, tuiles et feuilles, cireur et polisseur et poseur tie tuiles en asphalte \u2014 Linoleum and muroleum, tile and sheet, rubber, tile antl sheet, waxer antl polisher antl asphalt tile layer.Aide et apprenti poseur tic linoleum, tie muroleum on tie caoutchouc, tuiles et feuilles, cireur et polisseur et poseur tie tuiles en asphalte \u2014 Helper antl apprentice, linoleum antl muroleum, tile and sheet, rubber, tile antl sheet, waxer antl polisher antl tsphalt tile layer.Préposé aux bouilloires (travail tie plancher seulement) \u2014 Kettleman (flooring only).Poseur de marbre \u2014 Marble setter.Polisseur tie marbre à la main \u2014 Hand marble polisher.Maçon \u2014 pierre (y compris tailleur sur le chantier) \u2014 Mason (stone) antl cutter on the job Poseur de planchers en mastic \u2014 Mastic floor layer.Finisseur de planchers en mastic \u2014 Mastic floor finisher.Peintre, décorateur \u2014 Painter-decorator.,.Peintre, au pistolet \u2014 Painter-sprayman.Vitrier \u2014 Glazier.Mécanicien tic machines génératrices à vapeur \u2014 Steam generator mechanic.Aide-mécanicien tie machines génératrices à vapeur \u2014 Steam generator mechanic's helper Poseur de brûleurs à l'huile, Classe \"A\" \u2014 Oil burner mechanic, Class \"A\".Poseur de brûleurs à l'huile, Classe \"B\" \u2014 Oil burner mechanic, Class \"B\".Peintre, fer structural et clochers \u2014 Structural steel antl steeplejack painter.Plâtrier (travaux ordinaires ou d'ornementation) \u2014 Plasterer (plain or ornamental).Couvreur, membrane rapportée et couverture à rouleau (asphalte et gravier) \u2014 Roofer \u2014 built-up membrane antl roll roofings (asphalt antl gravel).Préposé aux bouilloires \u2014 Kettleman.Gréeur \u2014 Rigger.Poseur tie métal en feuilles, couvreur-ardoise, tuiles, asphalte et bardeaux autres que ceux en bois, y compris le posage d'amiante gaufrée sur murs extérieurs et couvertures, de divisions tic chambres tic toilette et de tablettes en acier \u2014 Sheet metal worker, roofer \u2014 slate, tile, asphalt or shingle (excepting wood shingle) antl corrugated asbestos roofing antl siding antl including steel toilet partitions antl shelving.Soudeur, métal en feuille \u2014 Sheet metal welder.Préposé aux pelles mécaniques, par semaine \u2014 Shovel operator (power) per week.Lorsqu'il est employé moins de -44 heures dans une semaine \u2014 When cmployetl less than 44 hours during the week.Monteur et soudeur tie fer structural (toutes catégories) \u2014 Structural steel erector antl welder (all categories).Poseur tie tuiles \u2014 Tile setter.Poseur de terrazzo \u2014 Terrazzo layer.Préposé aux machines à polir le terrazzo (humide) \u2014 Terrazzo polishing machine operator (water polishing).Préposé aux machines à polir le terrazzo (sec) \u2014 Terrazzo polishing machine operator (dry) Chauffeur de camion, transport général et remorquage \u2014 General trucker (cartage and hauling).Charretier-, conducteur d'attelage double \u2014 Carter, teamdriver.par Vérificateur du matériel et pointeur (sans limite de la durée journalière du travail) \u2014 Material checker and time-keeper (without daily limitation as to hours of work).Surveillant (sans limite de la durée journalière du travail) \u2014 Watchman (without daily limitation as to hours of work).Surveillant employé également comme chauffeur et devant posséder un certificat de 4ième classe (sans limite de la durée journalière du travail) \u2014 Watchman employed also as fireman requiring 4th class certificate (without daily limitation as to hours of work) Homme de cour (sans limite de la durée journalière du travail) \u2014 Yardman (without daily lim'tation as to hours of work). QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1951, Vol.88, No.18 1409 par heure per hour Mécanicien de machines à vapeur ou eau chaude (surface de chauffe de 20') \u2014 Steam and hot water generation mechanics (heating surface 20 ft).1.32 Aide-mécanicien de machines à vapeur ou eau chaude (surface de chauffe de 20') \u2014 Steam and hot water generation mechanic's helper (heating surface 20 ft).1.07 Boni de vie chère : Il est reconnu et entendu Cost of living : It is recognized and understood entre les parties aux présentes que les taux ci- by the respective parties hereto that the fore-haut mentionnés comprennent la somme de going rates include a sum of twelve cents (80.12) SO.12 l'heure accordée en raison de l'augmenation per hour allowed to offset the increase in the cost du coût de la vie déterminée par le Bureau Fédé- of living as determined by the Dominion Bureau rai de la Statistique.Ladite augmentation of Statistics, being twenty (20) points or thereby étant de 20 points à compter du mois de février calculating from the month of February, 1950 1950 (10.4 points au 1er février 1951 et 3.7 points (10.4 to 1st Feb.1951 and 3.7 to 1st March au 1er mars 1951).1951).Lesdits taux seront majorés d'une somme de In view of anticipated further increases in the SO.03 l'heure à compter du 1er août, 1951, à titre cost of living, the foregoing rates shall be augm- dc compensation pour les nouvelles augmentations cnted by a sum of three cents (80.03) an hour prévues du coût de la vie.commencing from the 1st day of August 1951.3° Ce projet d'amendement n'entrera en vi- 3.This amendment shall not have effect, nor gucur ou ne sera rendu obligatoire par arrêté en shall it be rendered mandatory by Ordcr-in- conscil, que lorsque les parties de première Council until such time as a settlement has been et de deuxième part en seront venues à une en- reached by the first and second parties respecting tente au sujet de certaines modifications dans certain modifications in the conditions of labour les conditions de travail et dans la juridiction and trades jurisdiction demanded by the first des métiers, demandées par la partie de première party, part.Durant les trente jours à compter de la date During the thirty days following the date \"of dc publication de cet avis dans la Gazette officielle publication of this notice in the Quebec Official de Québec, l'honorable Ministre du Travail rece- Gazette, the Honourable Minister of Labour will vra les objections que les intéressés pourront consider the objections which the interestedtpar- désirer formuler.ties mav wish to set forth.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, f£ Québec, le 5 mai 1951.30074-o Quebec, May 5, 1951.30074-o Département de l'Agriculture Department of Agriculture Industrie Laitière Dairy Industry Commission de l'Industrie Laitière de la Dairy Industry Commission of the Province province de Québec of Quebec Ordonnance N° 51-Sp-V Order No.51-Sp-V Extrait des procès-verbaux des séances de la Excerpts from the proceedings of the meetings Commission de l'Industrie laitière de la pro- of the Dairy Industry Commission of the vinec de Québec.Province of Quebec.Séance du mardi, 1er mai 1951, tenue au bu- Meeting of Tuesday, May 1st, 1951, held in reau de la Commission de l'Industrie laitière, the office of the Dairy Industry Commission in à Québec, à 9.30 heures de l'avant-midi.Quebec, at 9.30 o'clock in the morning.Présents: MM.Orner E.Milot, président, Present: Messrs: Orner E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, commissaires, Joseph Hébert, Adrien Angers, Commissioners, Alphonse Savoie, secrétaire, C.A.Gamache, c.r., Alphonse Savoie, Secretary, C.A.Gamache, aviseur légal.K.C, Legal Adviser.La Commission décrète: It is exacted as follows: 1° La présente ordonnance s'applique à toute 1.The present Order applies to all milk deli- livraison de lait en bidon à un navire dans un vered in bulk to a steamship in all ports of the port de la province de Québec.ports of the Province of Quebec.2° Nonobstant toute disposition de quelque 2.Notwithstanding the provisions of any autre ordonnance de la Commission, nul mar- other Order of the Commission, no milk dealer chand de lait, ne peut offrir, vendre ou livrer du shall offer, sell or deliver milk to the owner of lait à un propriétaire de navire ou à une compa- a ship or to a steamship company at a price gnie de navigation à un prix inférieur à 64 cents inferior to 04 cents a gallon, le gallon.La présente ordonnance annule l'ordonnance The present Order cancels Order No.43-Sp-III N° 43-Sp-XII, publiée dans la Gazette officielle de published in the Quebec Official Gazette of May Québec du 8 mai 1943 et entrera en vigueur le jour 8th, 1943 and shall come into force on the date of de sa publication dans la Gazette officielle de Québec, its publication in the Quebec Official Gazette.Signé: Omer E.Milot, président, Signed: Omeh E.Milot, President, Joseph Hébert, commissaire, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, commissaire.Adrien' Angers.Commissioner.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.30077-o 30077-o 1410 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1951, Tome 83, N° 18 Département du Trésor Treasury Department Assurances Insurance Avis de nomination d'un liquidateur Notice of appointment of liquidator Avis est, par les présentes, donné qu'à une Notice is hereby given that on the 9th day of assemblée générale spéciale des membres de April 1951 at a special general meeting of the \"Canadian Rubber Factory Employees' Mutual members of \"Canadian Rubber Factory Empl- Benefit Association\" tenue le 9 avril 1951, le sous- oyees' Mutual Benefit Association,\" I, the under- signé, Walter Barry, 98 rue Hébert, Ville St- signed, Walter Barry, of 98 Hébert Street, Ville Laurent, a été nommé liquidateur des affaires de St.Laurent, was appointed Liquidator of the ladite société, conformément aux dispositions de affairs of the said Society, pursuant to the prov- l'article 276 de la Loi des assurances de Québec, isions of Section 276 of the Quebec Insurance Act.Toute réclamation contre ladite société doit Any claim against the said Society must be être produite sous serment déposée entre mes sworn to and filed with me within a delay of mains dans un délai de trente jours à compter thirty days from this notice, de la date de cet avis.Donné conformément à l'article 872 du Code Given pursuant to section 872 of the Code of de procédure civile, le 23 avril 1951.Civil procedure, this 23rd day of April 1951.Le Liquidateur, WALTER BARRY, 30035 WALTER BARRY.30035-o Liquidator.Liquidation, avis de Winding up Notice Avis est donné que, à une assemblée générale Notice is hereby given that, at a Special General spéciale des actionnaires de la compagnie Acadia Meeting of the Shareholders of Acadia Apart- Apartments Limited tenue en la cité de Montréal, ments Limited\", held at the City of Montreal, P.Q., le 28 mars 1951, une résolution a été passée P.Q., on the 28th day of March 1951, a resolution stipulant que ladite compagnie soit liquidés volon- was passed providing that the said Company be tairemcnt et dissoute, conformément aux dispo- wound-up voluntarily and dissolved, pursuant sitions de la Loi de la liquidation volontaire des to the provisions of the Winding-up Act, R.S.Q.compagnies à fonds social, S.R.Q.,1941, chapitre 1941, chap.278, and that, for such purpose, 278, et que, à cette fin.la compagnie Montreal Montreal Trust Company, Montreal, P.Q., was Trust Company, Montreal, P.Q.a été nommée appointed Liquidator of the said Company, liquidateur de ladite compagnie.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, Given at the office of the Provincial Secretarv, le 30 avril 1951.this 30th day of April, 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 30052 JEAN BRUCHÉSI.30052-q Under-Secretary of the Province.Ordre de Cour Rule of Court Province de Québec, District de St-François, Province of Quebec, District of St.Francis, in dans la Cour Supérieure.N° 8822.Cruickshank the Superior Court.No.8822.Cruickshank & -& Packard Reg'd, demandeurs, vs Gordon Packard Reg'd., plaintiff, vs Gordon Hawes, Hawes, défendeur et The Canadian Bank of defendant & The Canadian Bank of Commerce, Commerce, opposant.opposant, Ordre de cour Rule of Court Sur ordre de l'Honorable Juge Wm.Mitchell, Upon order of Honourable Justice Wm.Mit- donné le vingtième jour d'avril 1951, vu l'allé- chell given on the twentieth day of April one gation d'insolvabilité du dit défendeur Gordon thousand nine hundred and fifty-one, seeing the Hawes de North Hatley, district de St-François, allegation of insolvency of the said defendant, les créanciers du dit défendeur qui n'auraient Gordon Hawes, of North Hatley, district of St.pas encore produit leur réclamation, sont main- Francis, the creditors of the said defendant who tenant appelés à les produire, en cette cause au have not yet filed their claims, are now called bureau du protonotaire de la Cour Supérieure upon to file same in this case, at, the office of pour ce district, à Sherbrooke, dans les quinze the Prothonotary of the Superior Court for the jours de la date de la première insertion du pré- said district, at Sherbrooke, within fifteen days sent avis dans la Gazette officielle de Québec, from the date of the first insertion of the present conformément aux articles 673 et 674 du Code notice in the Quebec Official Gazette, pursuant to de Procédure Civile.article 673 and 674 of the Code of Civil Procedure.Sherbrooke, le 23 avril, 1951.Sherbrooke, April 23rd, 1951, Le P.C.S.ALBERT DÉSILETS, 30042-18-2-o ALBERT DÉSILETS.30042-18-2-o P.S.C. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1961, Vol.S3, No.18 1411 Sièges sociaux Louis Brunelet & Cie, Ltée Le siège social de la compagnie susdite est au N° 100 de la rue du Pont, Quebec, P.Q.Le Secrétaire-trésoi ier, 30032-o Louis Brunelet.City Parcel Delivery Inc.Avis est donné que la compagnie \"City Parcel Delivery Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec en date du 5 mars 1951, et ayant son siège social en la cité de Montréal, où son bureau était situé jusqu'à ce jour à 1188 Preston Lane, l'a ransportéà 1267 rue Barre.Daté à Montréal, Québec, le 5 avril 1951.(Sceau) Le Président, 30039 J.P.KNOWLTON.\"Marcel LaCasse Fourrures Limitée\" Avis de changement d'adresse \"Marcel LaCasse Fourrures Limitée\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 13 novembre 1947 en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, qui avait son bureau principal à 320 rue Notre-Dame est, Montréal, donne avis que son bureau principal est maintenant situé à 1186 rue Sainte-Catherine ouest, Montréal.Montréal, le 26 avril 1951.Le Président, 30040-o J.-C.BELLE ISLE.' Avis est donné que la compagnie \"North American Management Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du vingt-deux août mil neuf cent quarante-neuf, et ayant son siège social à Montréal, où son bureau était situé jusqu'à ce jour à 1709, édifice Aldred, 507 Place d'Armes, Montréal, P.Q., l'a transporté à chambre 1806, édifice de la Banque Royale, 360 rue St-Jacques, Montréal, P.Q.Le Gérant, 30041 J.A.HAYMAN.Adanac Chemical Products of Canada Limited Avis de situation du siège social Avis est donné que la compagnie \"Adanac Chemical Products of Canada Limited\", constituée en coropration par lettres patentes, en date du 25 janvier 1951, et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, a établi son bureau au numéro civique, 1500 ouest, rue Ste-Catherine.A compter de la date du présent avis, le dit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 25 mars 1951.Le Président, 30064 NORBERT ALVES PROBST.Head Offices Louis Brunelet & Cie, Ltée The above mentioned company's head office is at number 100 du Pont Street, Québec, P.Q.Louis Brunelet, 30032-o Secretary-Treasurer.City Parcel Delivery Inc.Notice is hereby given that \"City Parcel Delivery Inc.\", incorporated by Letters Patent of the Province of Quebec, on the 5th day of March, 1951, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated up to today at 1188 Preston Lane, has moved it to 1267 Barre Street.Dated at Montreal, Quebec, this 5th day of April, 1951.(Seal) J.P.KNOWLTON, 30039-o President.\"Marcel LaCasse Fourrures Limitée\" Notice of change of address \"Marcel LaCasse Fourrures Limitée\" incorporated by letters patent bearing date the 13th of November, 1947, under the Quebec Companies Act, the head office whereof was situated at 320 Notre-Dame Street East, Montreal, gives notice that its head office is now situate at 1186 Saint Catherine Street West, Montreal.Montreal, April 26, 1951.J.C.BELLE ISLE, 30040 President.Notice is hereby given that \"North American Management Corporation\" incorporated by Letters Patent on the twenty second day of August, Nineteen Hundred and Forty Nine, and having its Head Office in Montreal, where its office was situated up to today at 1709, Aldred Building, 507, Place d'Armes, Montreal, P.Q., has moved it to Room 1806, The Roya.l Bank Building, 360, St.James Street, Montreal, P.Q.J.A.HAYMAN, 30041-o ' Manager.Adanac Chemical Products of Canada Limited Notice of Situation of Head Office Notice is hereby given that the Adanac Chi-mical Products of Canada Limited, incorporated by Letters Patent on the 25th day of January 1951 and having its head office in the City and District of Montreal has established its office at civic number 1500 St.Catherine Street West.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 25th day of March 1951.NORBERT ALVES PROBST, 30064-o President. 1412 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1951, Tome 83, N° 18 Frank Round & Son Ltd.Avis est donné que la compagnie Frank, Round & Son Ltd., constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec en dale du 5 janvier 1951, a établi son siège social au N° 1860 ouest, rue Stc-Catherine, Montréal.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, Québec, le 30 avril 1951.Le Président.30053 FRANK' ROUND.The Potters, Inc.Avis est donné que la compagnie \"The Potters, Inc.\", \u2022 constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la troisième, partie de la Loi des compagnies de Québec en date du 3 avril 1951, et ayant son siège social en les cité et district de Montréal, a établi son siège social à 320 avenue Elm, YYestmount, P.Q.Daté à Montréal, le 25 avril 1951.The Potters, Inc.Par la Secrétaire, 30005 FLORENCE BUCKLER.Frank Round & Son Ltd.Notice is hereby given that Frank, Round & Sen Ltd., was incorporated in the Province of Quebec by Letters Patent dated January 5th, 1951, has established its Head Office at No.1S00 St.Catherine Street West.Montreal.From and nftcr the date of this notice the said (.flice shall be considered by the company as being the head office ':f the company.Dated at Montreal Quebec, this 30th day of April 1951.FRANK ROUND, 30053-o President.The Potters, Inc.Notice is hereby given that \"The Potters, Inc.\", incorporated by Letters Patent issued under Paît III of the Quebec Companies' Act on the 3rd day of April, 1951, and having ist Head Office in the City and District of Montreal, has established its Head Office at 320 Elm Avenue, West mount, P.Q.Dated at Montreal, this 25th day of April, 1951.The Potters, Inc\\ Per FLORENCE BUCKLER, 30065-o Secretary.Soumissions Commissaires d'Écoles pour la Municipalité de Grand'Mère (Comté de Champlain) Prière de noter que les soumissions demandées la semaine dernière pour l'achat de 8-100,000 d'obligations de cette commission scolaire devront être faites à un taux fixe de V/f/o-30068-o Province de Québec Ville de KéNOGAMi (Comté de Chicoutimi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné.R.Coulombe, greffier, CP.25, Kénogami, comté de Chicoutimi, jusqu'à 8 heures p.m.lundi le 21 mai 1951, pour l'achat de S 100,000 d'obligations de la ville de Kénogami.datées du 1er mai 1951 et remboursables par séries du 1er mai 1952 au 1er mai 1971 inclusivement avec intérêt à un taux n'excédant pas 4% par année payable semi-an-nuellcmcnt les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 S400,000 \u2014 20 ans.Année Capital 1er mai 1952.S 4,000.00 1er mai 1953 .4,000.00 1er mai 1954.4.000.00 1er mai 1955.18,000.00 1er mai 1956.18,500.00 1er mai 1957.19,500.00 1er mai 1958 .20,000.00 1er mai 1959 .20,500.00 Tenders School Commissioners for the Municipality of Grand'Mère * (County of Champlain) Please note that the tenders called last week for the purchase of 8400,000 of bonds of this School Commission must be for a fixed interest rate of 3>^%.30008-o Provint c of Quebec Town of Kenigamie (County of Chicoutimi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders fer Ronds\", will be received by the undersigned R.Coulombe, clerk, P.O.Box 25*Kcnogami, county of Chicoutimi, up to 8 o'clock P.M.on Monday, May 21, 1951, for the purchase of S 100,000 of bonds
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.