Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 19 (no 20)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1951-05-19, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 83, N° 20 1487 Vol.83, No.20 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 19 mai 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût «les annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5 L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 1 Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, may 19th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheq'ie, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa.Canada, wa, as second class mailable matter. 1488 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome S3, N° 20 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de letarder la publication de certains documents, a cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une premièfe insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 2GG lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie 3ue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u20141-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.Tf a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties arc requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 206 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u2014 1-52 Lettres patentes Letters Patent Anchor Investments Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies tic Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1911, des lettres patentes en date du 12 mars 1951, constituant en corporation: Samuel Chait, avocta, Harry Lyon Aronovitch, avocat, et Freda Pomcrance, secretaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger comme une corporation de portefeuille et de placements sous le nom de \"Anchor Investments Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Anchor Investments Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276,R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of March, 1951, incorporating: Samuel Chait, advocate, Harry Lyon Aronovitch, advocate, and Freda Pomcrance, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Anchor Investments Limited\", with a capital stock of S40.000.divided into 100 common shares of the par value of $100.each, and 300 preferred shares of the par value of $100 .each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.9 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol 83, No.SO 1489 Association des Industriels de Rimouski Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conforméemnt à l'article 2.chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du neuf mars 1951, constituant en corporation sans Capital-actions: Arthur Gendreau, avocat, Pierre-Paul Gagnon, médecin, et Gabriel Gagnon, employé civil, tous de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, sous le nom de \"Association des Industriels de Rimouski\".Les pouvoirs accordés ne permettent pas les jeux à l'argent,.les jeux de hasard, les jeux de hasard et d'habileté, les paris illégaux, et ne permettent pas non plus à la corporation de demander, obtenir ou exploiter une licence octroyée par la Commission des Liqueurs de Québec; Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, ' 30137-o L.DÉSILETS.Association des Propriétaires de Chevaux de Course sous Harnais The Association of Owners of Harness Race Horses Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Jo-saphat Couture, bourgeois, H.Moreau, rentier, «le la cité de Montréal, Arcade Lemay, cordonnier, «le Pointe-aux-Trembles, et Jean Jodoin, culti-valucr, de Longueuil, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Protéger les intérêts des propriétaires de chevaux de course sous harnais, sous le nom de \"Association des Propriétaires de chevaux de Course sous Harnais\" \u2014 \"The Association of Owners of Harness Race Horses\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Atta Girl Frocks Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-ticux mars 1951, constituant en corporation: Albert Malouf, avocat, Joseph Rodolphe Lemire, agent, tous deux d'Outremont, Peter Shorteno, avocat, de la ville de Mont-Royal, et Claire La-pointe, fille majeure, de la cité de Montréal, tous «lu district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Association des Industriels de Rimouski Notice is hereby given that under Part IH of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Arthur Gendreau, advocate, Pierre-Paul Gagnon, physician, and Gabriel Gagnon, civil servant, all of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To promote the economic, social and moral interests of its members, under the name of \"Association des Industriels de Rimouski\".The powers granted do not allow gambling, games of chance or mixed games of chance and skill, illegal betting, nor do they allow the corporation to apply for, secure or operate a license granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will beat Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Association des Propriétaires de Chevaux de Course sous Harnais The Association of Owners of Harness Race Horses Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Josaphat Couture, retired, H.Moreau, annuitant, of the city of Montreal, Arcade Lemay, shoemaker, of Pointe-aux-Trembles, and Jean Jodoin, farmer, of Longueuil, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To protect the interests of owners of harness race horses, under the name of \"Association des Propriétaires de Chevaux de Course sous Harnais\" \u2014 \"The Association of Owners of Harness Race Horses\".The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $20,000.The.head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Atta Girl Frocks Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1951, incorporating: Albert Malouf, advocate, Joseph Rodolphe Lemire, agent, both of Outremont, Peter Shorteno, advocate, of the Town of Mount-Royal, and Claire Lapointe, spinster, of the city of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: 1490 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 Manufacturer et faire le commerce de vêtements et toutes les variétés de tissus accessoires d'habillement sous le nom de \"Atta Girl Frocks Limited\", avec un capital de §40,000 divisé en 3,000 actions communes d'une valoir au pair de $10 chacune, et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.To manufacture and deal in wearing apparel and all other kinds of materials and accessories for wearing apparel, under the name of \"Atta Girl Frocks Limited\", with a capital stock of $40,000.divided into 3,000 common shares of the par value of S10.each, and 1,000 preferred shares of the par value of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated .at the office of the Attorney General, this twenty-second day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Atelier Bureau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mars 1951, constituant en corporation: Pierre Bureau, Philippe Bureau, ébénistes, et Paul Bureau, menuisier, tous de Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Xoranda, pour les objets suivants : Entreprendre la fabrication, l'achat, la vente, la réparation de meubles et articles meublants, en bois, métal, cuir, plastic et les sous produits d'iceux; faire le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Atelier Bureau Limitée\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Roùyn, district judiciaire de Rouyn-Xoranda.Daté du bureau du Procureur général le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Atelier Bureau Limitée Xotice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1951, incorporating: Pierre Bureau, Philippe Bureau, cabinet makers, and Paul Bureau, joiner, all of Rouyn, judicial district of Rouyn-Xoranda, for the following purposes: To engage in the manufacturing,, buying, selling and repairing of furniture and household effects in wood, metal, leather, plastic and the by-products thereof; to carry on the busines of general contractors, under the name of \"Atelier Bureau Limitée\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Xoranda.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Baievillc Wandering Foot Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze mars 1951, constituant en corporation: Dr Simon Biron, médecin vétérinaire, Robert Bélisle, contraetcur, et Clovis Gauthier, restaurateur, tous de Baieville, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Manufacturer toutes sortes d'escarpins, pantoufles, sandales et toutes chaussures quelconques; Manufacturer tous bas, chaussettes, mitaines, gants et tous tricots en laine, sous le nom de \"Baieville Wandering Foot Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 800 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baievillc, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le douze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Binct & Turgcon Ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze mars 1951, constituant en corporation: J.-Viateur Turgcon, Benoit Binct et René Tur- Baicville Wandering Foot Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by M.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of March, 1951, incorporating: Dr.Simon Biron, veterinary surgeon, Robert Belisle, contractor, and Clovis Gauthier, restaurant-keeper, all of Baieville, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To manufacture all kinds of shoes, slippers, sandals and any kind of footwear whatsoever; To manufacture all kinds of stockings, socks, mittens, gloves, and any knitted goods, under the name of \"Baieville Wandering Foot Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 800 shares of 850 each.The head office of the company will be at Baieville, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Binct & Turgcon Ltéc Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, tearing date the twelfth day of March, 1951, incorporating: J.Viateur Turgcon, Benoit Binet and René Turgeon, manufac- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.20 1491 geon, manufacturiers, de Beauceville Est, district judiciaire de Beauce: pour les objets suivants: Faire affaires dans le commerce ou l'industrie des ligueurs douces, épiceries et provisions de toutes sortes, sous le nom de \"Binet & Turgcon Ltée\", avec un capital\" de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beauce-ville-Est, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le douze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.turers, of Beauceville Est, judicial district of Beauce, for the following purposes: To carry on the business or industry of soft drinks, groceries and provisions of every kind, under the name of \"Binet & Turgeon Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Beauceville-est, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Brochu et Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1951, constituant en corporation: Joseph-N.Brochu, Laval Brochu, commerçants, de Saint-Henri de Lévis, et Fernand Brochu, commerçant, de la cité de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce comme boucliers, épiciers, sous le nom de \"Brochu et Fils Ltée\", avec un capital de $50,000 divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social dé la compagnie sera à 568, rue Ste-Thérèse, cité de Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Brochu et Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the .Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1951, incorporating: Joseph N.Brochu, Laval Brochu, traders, of Saint-Henri de Levis, and Fernand Brochu, trader, of the city of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as butchers, grocers, under the name of \"Brochu et Fils Ltée\", with a capital stock of $50,000, divided into 2,500 common shares of a par value of $10 each, and 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 568 Ste.Thérèse Street, city of Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1951.L.DÉSILETS.30137 Deputy Attorney General.Century Builders Ltd.Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du 8 mars 1951, constituant en corporation: Claude Gagnon, marchand de bois de construction, de la cité de St.Laurent, Georges Langevin, marchand de bois de construction, et Ernest St-André, entrepreneur, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Conduire et exercer l'industrie de constructeurs et entrepreneurs en général, sous le nom de \"Century Builders Ltd.Ltée\", avec un capital de 860,000 divisé en 1,080 actions privilégiées ayant une valeur au pair de $50 chacune et 600 actions ordinaires ayant une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Century Builders Ltd.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of March, 1951, incorporating: Claude Gagnon, lumber dealer, of the Town of St.Laurent, Georges Langevin, lumber dealer, and Ernest St-An-dré,.contractor, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and general contractors, under the name of \"Century Builders Ltôl.Ltée\", with a capital stock of 860,000.divided into 1,080 preferred shares having a par value of $50 each and 600 common shares having a par value of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-0 Deputy Attorney General.Charest & Frères Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mars 1951, constituant encorpora-tion: Hélène Antonuk/'Annette Lafleur, secrétaires, Robert Levesque, chef de bureau, Charles-A.Charest & Frères Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-_Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1951, incorporating: Hélène Anto-nuk, Annette Lafleur, secretaries, Robert Levesque, office chief, Charles A.Lussier, advocate, 1492 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° SO Lussier, avocat, et Henri Dessaulles, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire, bâtir, réparer et modifier des édifices et autres constructions et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Charcst & Frères Ltéc\", avec un capital de 840,000 divisé en 40,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Cinéma Loma Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1951, constituant en corporations: Henri-Paul Lemay, Paul Edouard Ross, avocats, et Ghislaine Gagné, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Posséder, louer et exploiter des théâtres, sous le nom de \"Cinéma Loma Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Windsor district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.and Henri Dessaulles, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To build, erect, repair and alter buildings and other structures and deal in building materials, under the name of \"Charcst & Frères Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 40,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Cinéma Loma Inc.Notice is hereby given that under' Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, incorporating: Henri Paul Lemay, Paul Edouard Ross, advocates, and Ghislaine Gagné, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To own, lease and operate theatres, Under the name of \"Cinéma Loma Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 390 preferred shares of a a par value of $100 each, and 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Windsor, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Convention Furs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: June Kirlin, Mavis Grand, Sylvia Rabi-novich et Marie-Paidc Hudon secrétaires, filles majeures, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de la fourrure brute et de la fourrure préparée et marchandise en fourrure de toute sorte et description, sous le nom de \"Convention Furs Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.^ Daté du bureau du Procureur général ce vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Convention Furs Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951, incorporating: June Kirlin, Mavis Grant, Sylvia Rabinovich and Maric-Paule Hudon, secretaries, spinsters of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with raw and dressed furs, and fur products of every kind and description, under the name of \"Convention Furs Inc.\", with a capital stock of S40.000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Dependable Knitting Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du 13 mars 1951, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Outremont, Samuel Greenblatt, avocat, et Sonya Schneyer, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire do Montréal, pour les objets suivants: Dependable Knitting Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of March, 1951, incorporating: Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outremont, Samuel Greenblatt, advocate, and Sonya Schneyer, secretary, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.SO 1493 Manufacturer et faire le commerce et le négoce de marchandises tricotés, lainages ou autres vêtements manufacturés et tissus pour vêtement, sous le nom de \"Dependable Knitting Co.Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.To manufacture, deal in and with knitted goods, woollen or otherwise, manufactured articles of clothing and cloth goods, under the name of \"Dependable Knitting Co.Ltd.\", with a capital stock of $20,000.divided into 200 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirteenth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.D.II.Grosvenor Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du sept mars 1951, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, et Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Outremont.tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers, vendeurs de toutes sortes de fourrures, vêlements et accessoires en fourrure, sous le nom de \"D.H.Grosvenor Inc.\", avec un capital de $50,000 divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune, et 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2024 rue Pcel .Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.D.H.Grosvenor Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1951, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, secretary, both of the City of Montreal, and Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers, dealers in all kinds of furs and fur garments and accessories, under the name of \"D.H.Grosvenor Inc.\", with a capital stock of $50,000.divided into 3,000 preferred shares of the par value of $10.each, and 200 common shares at the par value of $100.each.' The head office of the Company will be at 2024 Pcel St., Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, , 30137-o Deputy Attorney General.Dibblee \u2014 Chase Tools Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quatorze mars 1951, constituant en corporation: Royal Ernest Cari Werry, avocat et conseil en loi du Roi, Lcpha Clogg Robertson, veuve, sténographe, tous deux de la cité de Westmount et Joseph Helal, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de machinerie d'usines, appareils, outils, instruments, ustensiles, substances, matériaux et choses utilisés relativement à toutes ou aucune des fins susdites et/ou de leurs accessoires, sous le ^ nom de \"Dibblee\u2014Chase Tools Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Dibblee \u2014 Chase Tools Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of March, 1951, incorporating: Royal Ernest Carl Werry, advocate and King's Counsel, Lepha elogg Robertson, widow, stenographer, both of the City of Westmount, and Joseph Helal, advocate and King's Counsel, of the city of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of plant machinery, apparatus, tools, implements, utensils, substances, materials and things used in connection with all or any of the aforesaid purposes and /or accessories of the same, under the name of \"Dibblee\u2014Chase Tools Limited\", with a capital stock of S50.000.divided into 500 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney this fourteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Doncar Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date Doncar Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day 1494 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1961, Tome S3, N° 20 du huit mars 1951, constituant en corporation: Don Cardiff, consultant et aéronautique, de la cité de Rio de Janiero, Brésil, Jeanne Bourdages, secrétaire, et Charles Wolfson avocat tous deux de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie d'im-meùbles et de placements, sous le nom de \"Don-car Investments Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune, et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.of March, 1951, incorporating: Don Cardiff, aviation consultant, of the City of Rio de Janiero, Brazil, Jeanne Bourdages, secretary, and Charles Wolfson, advocate, both of the City of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of Dun-car Investments Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 100 common shares of $100.each, and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-0 Deputy Attorney General.Dorval Automobile Transport Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf mars 1951, constituant en corporation: Paul-Antoine Perras, promoteur de ventes, de la cité d'Outrcmont, Salaberry Beaudry, inspecteur, du téléphone, de la cité de Lachinc, tous deux du district judiciaire de Montréal, et Stanley Brown, camionneur, de la cité de Windsor, province d'Ontario, pour les articles suivants: Exercer le commerce de rouliers en général, sous le nom de \"Dorval Automobile Transport Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Dorval Automobile Transport Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, incorporating: Paul-Antoinc Perras, sales promoter, in the City of Outremont, Salaberry Beaudry, telephone supervisor, of the City of Lachine, both in the Judicial District of Montreal, and Stanley Brown, trucking operator, of the \"City of Windsor, Province of Ontario, for the following purposes.: To carry on the business of general common carriers, under the name of \"Dorval Automobile Transport Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o * Deputy Attorney General.Drummond Taylor Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: Joseph Moorc, Robert Lafleur, tailleurs, et Pierre Jutras, avocat, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Faire affaire comme tailleurs, manufacturiers, dessinateurs et vendeurs généraux dans le vêtements et dans tous les autres articles de mercerie et de lingerie, sous le nom de \"Drummond Taylor Company Limited\", avec un capital de $35,000 divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoria-ville, district judiciaire de d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Duplex Window Attachment, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: Roger Paradis, industriel,i,Joseph-Onésime Du- Drummond Taylor Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: Joseph Moore, Robert Lafleur, tailors, and Pierre Jutras, advocate, all of Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on business as tailors, manufacturers, designers and general dealers in wearing apparel and all other articles of heaberdashery and clothing, under the name of \"Drummond Taylor Company Limited\", with a capital stock of $35,000 divided into 1,500 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.^ The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Duplex Window Attachment, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of .the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: Roger Paradis, industrialist, Joseph Onésime Dubois, store QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.SO 1495 hois, gérant de magasin, et Lucien Marcoux, cultivateur, tous trois de Plessisville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: .Fabriquer, manufacturer, vendre et faire le commerce de ferrures ou attaches pour fenêtres et impostes et généralement de toutes ferrures et de tous articles de métal gravés ou poinçonnés, de fenêtres et chassis en bois ou en métal, sous le nom de \"Duplex Window Attachment, Ltd,\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,600 actions de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera Plessisville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1951.L'Assistant-procureur general, 31037-o L.DÉSILETS.manager, and Lucien Marcoux, farmer, all three of Plessisville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To manufacture, make, sell and deal in window fastenings, attachments and springers and in general all fastenings and articles in engraved or perforated metal, windows and sashes in wood or metal, under the name of \"Duplex Window Attachment, Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 1,600 shares of $25.each.The head office of the company will be at Plessisville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.East & Masson Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit mars 1951, constituant en corporation: ,I.-Mcndoza East, Hcrménégilde Masson, con-tracteurs, et Yves Masson, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs en construction et distributeurs de matériaux de construction, sous le nom de \"East & Masson Inc.\", avec un capital en $90,000 divisé en 900 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Flor-O-Lac Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>cc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>cc, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 27i'.S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: < iermain Charland, avocat, Gaston Descheneaux, huissier, tous deux de la cité de Montréal,, et Joseph-Raphaël Charland, avocat, de Ville M ont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants :_ Faire le commerce de produits chimiques, produits sanitaires; et en général de tous articles, produits ou accessoires quelconques pouvant servir à entretenir, orner ou meubler les maisons, magasins ou toutes autres habitations quelconques, sous le nom de \"Flor-O-Lac Co.Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général.30137-o L.DÉSILETS.lieras Richard & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a East & Masson Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing daté the eighth day of March, 1951, incorporating: J.Mendoza East, Hcrménégilde Masson, contractors and Yves Masson, accountant, all of the city and judicial district of Quetec, for the following purposes: To act as building contractors and distributors of building materials, under the name of \"East & Masson Inc.\", with a capital stock of $90,000 divided into 900 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Flor-O-Lac Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quelle, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section, 2 chapter 276, R.S.Q., 1941, tearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: Germain Charland advocate, GastonJ)escheneaux.bailiff, both of the city of Montreal, and Joseph Raphaël Charland, advocate, of the Town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in chemical products, sanitary supplies and generally all articles, products or supplies whatsoever capable of being used to maintain, decorate or furnish houses, stores of other dwellings whatsoever, under the name of \"Flor-O-Lac Co.Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Heras Richard~& Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have 1496 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: lieras Richard, industriel, Stanislas Richard, Roger Richard, mécaniciens, tous de Palmarollc, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Opérations forestières, exploitation de scieries, moulins à préparer le bois, et commerce de bois de toutes sortes, en général, sous le nom de \"Héras Richard & Fils Ltée\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Palmarollc, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mais 1951.L'Assistant-procureur généra 1.30137-o L.DÉSILETS.Jewish Convalescent Home of Montreal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1951, constituant en corporation: sans capital-actions: Moses Bercovitz, Samuel David Gross, Jacob Cryer, Pincus Tendler, Jacob Libcrman, John Levine, manufacturiers, Harry Ruberstein, Mike Mintz, Lewis Azef, Charles Shiller, Louis Cohen, Benjamin Baril, Joe Zummer, Ben Luber et Maurice Singer, marchants, Harvey Caplan, médecin, Moses Mosco-vitch, avocat, Samuel Grossman, fourreur, Ave Farberovitch et Ben Harper, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir, exploiter et diriger une maison de convelescencc, sous le nom de \"Jewish Convalescent Home of Montreal Inc.\" Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS, been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: Héras Richard, industrialist, Stanislas Richard, Roger Richard, mechanics, all of Palmcrollc, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To engage in lumbering operations, operate saw mills and mills for preparing lumber and to deal generally in lumber of all kinds, under the name of \"Héras Richard & Fils Ltée\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Palmarollc, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Jewish Convalescent Home of Montreal Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1951, incorporating without share capital: Moses Bercovitz, Samuel David Gross, Jacob Cryer, Pincus Tendler, Jacob Liberman, John Levine, manufacturers, Harry Wolfe Ru-benstein, Mike Mintz, Lewis Azef, Charles Shiller, Louis Cohen, Benjamin Bril, Joe Zummer, Ben Luber and Maurice Singer, merchants Harvey Caplan, physician, Moses Moscovitch, advocate, Samuel Grossman, furrier, Abe Farberovitch, and Ben Harper, clerks, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To establish, operate and conduct a convalescent home, under the name of \"Jewish Convalescent Home of Montreal, Inc.\", The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav hold is to be limited is $100,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Josef Aron Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze mars 1951, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, C.R., Manuel Shacter, avocats et Anne Ross, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opération d'une compagnie de p'acements sous le nom de \"Josef Aron Inc.\" avec un capital de $175,000 divisé en 1,650 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et de 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mars 1951., L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Josef Aron.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of March, 1951, incorporating: Louis H.Rohrlick, K.C., Manuel Shacter, advocates, and Anne Ross, secretary, spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Josef Aron Inc.\", with a capital stock of $175,000.divided into 1,650 preferred shares of the par value of $100.each, and 100 common shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of March, 1951.L.DJaSILETS, 30137-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.88, No.20 1497 J.Robert Boisvert et Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du quatorze mars 1951, constituant en corporation: .1.-Robert Boisvert, commerçant, Raymond Boisvert, mécanicien, et Robert Boisvert, étudiant, tous d'Acton Valc, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles et autres véhicules, pièces et accessoires; exploiter un ou plusieurs garages, sous le nom de \"J.Robert Boisvert et Fils Limitée\", avec un capital de S40.G00, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Acton Yalc, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Keen Cartage Co.Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1951, constituant en corporation: Jean-Bcrchmans Bélanger, Hubert Desjardins et Pascal Di Maulo, comptables, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de camionneurs et faire le transport de toutes marchandises ou autres articles, sous le nom de \"Keen Cartage Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de S100 echacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.La Cic de Construction de Matapédia Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1951.constituant en corporation: Joseph-Rosaire Bérubé, avocat, Benoit Bérubé, commerçant, et Henri Dubé, contraetcur tous d'Amqui, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de construction, sous le nom de \"La Cie de Construction de Matapédia\", avec un capital de $40.000 divisé en 200 actions ordinaires de la valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de la valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amqui, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.La Cie d'Expansion Industrielle de Rigaud Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date J.Robert Boisvert et Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of March, 1951, incorporating: 'J.Robert Boisvert, trader, Raymond Boisvert, mechanic, and Robert Boisvert, student, all of Acton Val judicial district of Saint Hyacinthe, for the following purposes: To deal in automobiles and other vehicles, parts and accessories; operate one or more garages, under the name of \"J.Robert Boisvert et Fils Limitée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Acton Vale, judicial district of Saint Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Keen Cartage Co.Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1951, incorporating: Jean-Berch-mans Bélanger, Hubert Desjardins, and Pascal Di Maido, accountants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes* To carry on business as truckmen, and carry on the transportation of any merchandise or other articles, under the name of \"Keen Cartage Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March.1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.La Cie de Construction de Matapédia Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, incorporating: Joseph Rosaire Bérubé, advocate, Benoit Bérubé, trader, and Henri Dubé, contractor, all of Amqui, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To act as a construction company, under the name of \"La Cie de Construction de Matapédia\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of a par value of $100 each, and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Amqui, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.La Cie d'Expansionlndustriellc de Rigaud^Ltee Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh 1498 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 du sept mars 1951, constituant en corporation: ,T.-Marc Séquin, courtier d'assurances, Antonio Bussière, imprimeur, et Clément Binette, marchand général, tous de Rigaud, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir l'expansion industrielle dans Rigaud et la construction de bâtisses pour l'industrie, sous le nom de \"La Cie d'Expansion Industrielle de Rigaud Ltée\", avec un capital de 870,000 divisé en 300 actions ordinaires de $50 chacune, en 700 actions privilégiées de classe \"A\" d'une valeur au pair de $50 chacune, et en 4000 actions privilégiées de classe \"B\" d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rigaud, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Lantern Inn Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize mars 1951, constituant en corporation: Alfred Tourigny, C.R., avocat, Rita Dufresne et Lucienne Mérineau, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Tenir un hôtel, maison de touriste, sous le nom de \"Lantern Inn Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Magog, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le treize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.L'Association des Chemins d'Hiver de Ste-Gertrude Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quinze mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Bruno Gaudct, cultivateur, Engelbert Cormier, chauffeur, et Robert Lessard, garagiste, tous trois de la paroisse de Ste-Gertrude, district judiciaire de Nicolet, pour les objets suivants: Le droit d'entretenir des chemins d'hiver à Bécancourt, Ste-Gertrude, St-Sylvère, dans le comté de Nicolet, et Maddington Falls, dans le comté d'Arthabaska, et les environs, sous le nom de \"L'Association des Chemins d'Hiver de Ste-Gertrude\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à Sainte-Gertrude, district judiciaire de Nicolet.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.day of March, 1951, incorporating: J.Marc Séguin, insurance broker, Antonio Bussière, printer, and Clément Binette, general merchant, all of Rigaud, judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote the industrial expansion of Rigaud and the construction of buildings for industrial purposes, under the name of \"La Cie d'Expansion Industrielle de Rigaux Ltée\", with a capital stock of $70,000 divided into 300 common shares of $50 each, 700 class \"A\"preferred shares of a par value of $50 each and 4000 class \"B\" preferred shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Rigaud, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Lantern Inn Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quelle, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of March, 1951, incorporating: Alfred Tourigny, K.C., advocate, Rita Dufresne and Lucienne Mérineau, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To maintain a hotel, tourist home, under the name of \"Lantern Inn Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Magog, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.L'Association des Chemins d'Hiver de Ste-Gertrude Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Bruno Gaudet, farmer, Engelbert Cormier, chauffeur, and Robert Lessard, garage-keeper, all three of the parish of Ste-Gertrude, judicial district of Nicolet, for the following purposes: The right of maintaining winter roads at Bécancourt, Ste-Gertrude, St-Sylvère, in the county of Nicolet, and Maddington Falls, in the county of Arthabaska, and the environs, under the name of \"L'Association des Chemins d'Hiver de Ste-Gertrude\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation will be at Sainte-Gertrude, judicial district of Nicolet.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.20 1499 L'Association des Livreurs de lait du Saguenay Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred .Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-six février 1951, constituant en corporation: Gérard Bélanger, laitier, de Kénogami, Paul Talbot, Ccrenus Tremblay, Stanislas Des-chêne, tous laitiers, de Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire affaires comme manufacturiers, acheteurs, vendeurs, de beurre, fromage, crème, lait, tous les produits et sous-produits du lait, les œufs, les volailles, la viande, le poisson et produits agricoles, sous le nom de \"L'Association des Livreurs de Lait du Saguenay Limitée\", avec un capital de §40,000 divisé en 100 actions privilégiées de S100 chacune et en 300 actions communes de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 315, rue Saint-David, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six février 1951.L'Assistant-procureur général, :î0137-o L.DÉSILETS.Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver des Deuxième et Quatrième rangs de St-Pascal, comté de Kamouraska, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph Landry, Marcel Lavoie et Ernest Charest, cul tivateurs, de Saint Pascal de Kamouraska, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Ouvrir et déblayer les deuxième et quatrième rangs de St-Pascal de Kamouraska, sous le nom de \"Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver des Deuxième et Quatrième Rangs de St-Pascal, comté de Kamouraska, Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de §10,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Pascal, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le huit mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Le Comité des Chemins d'Hiver du Lac Sorcier Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Paul Beaudoin, industriel de Grand'Mère, Hubert I'Vappier, cultivateur, de Saint-Paulin, et Emile Papillon, entrepreneur, des Trois-Rivières, tous du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: S'occuper de l'entretien et de la réparation des chemins d'hiver de la région du Lac Sorcier, dans le district des Trois-Rivières, sous le nom L'Association des Livreurs de lait du Saguenay Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-sixth day of February, 1951, incorporating: Gérard Bélanger, dairyman, of Kémogani, Paul Talbot, Cerenus Tremblay, Stanislas Deschênes, all dairymen, of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes : To carry on business as manufacturers, buyers, and vendors of butter, cheese, cream, milk and all milk products and by products, eggs, poultry, meat, fish and farm products, under the name of \"L'Association des Livreurs de Lait du Saguenay Limitée\", with a capital stock of §40,000 divided into 100 preferred shares of §100 each and 300 common shares of §100 each.The head office of the company will be at 315 Saint David street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver des deuxième et quatrième rangs de St-Pascal, comté de Kamouraska, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1951, to incorporated as a corporation without share capital: Joseph Landry, Marcel Lavoie, and Ernest Charest, farmers, of Saint-Pascal de Kamouraska, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To open and clear the second and fourth ranges of St-Pascal de Kamouraska, under the name of \"Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver des Deuxième et Quatrième Rangs de St-Pascal, Comté de Kamouraska, Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is §10,000.The head office of the corporation will be at Saint-Pascal, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Le Comité des Chemins d'Hiver du Lac Sorcier Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Jean Paul Beaudoin, industrialist, of Grand'Mère, Hubert Frappier, farmer, of Saint-Paulin, and Emile Papillon, contractor, of Trois-Rivières, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To engage in the maintenance and repair of winter roads in the region of Lac Sorcier, in the district of Trois-Rivières, under the name of 1500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome ,83, N° 20 de \"Le Comité des Chemins d'Hiver du Lac Sorcier\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 820,000.Le siège social de la corporation sera à Grand-Mère, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Lewis Brothers Asphalt Paving Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du treize mars 1951, constituant en corporation: Jack Ackart Lewis, Roy William Levis, entrepe-ncurs, de la ville de Mont-Royal, et Jeanne Drouin, secrétaire, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Pratiquer et exercer les opérations d'entrepreneurs et constructeurs en général, sous le nom de \"Lewis Brothers Asphalt Paving Limited\", avec un capital de 840,000 divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Ix; siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Make - Ur - Price Auto Sales Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: John Richard Hyde, Roland-Gérard Le-françois et Jean-Jules Gadbois, tous avocats des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce d'automobiles et autres véhicules moteurs, appareils électriques, de tous accessoires; exploiter des garages sous le nom de \"Make - Ur - Price Auto Sales Ltd.\", avec un capital de 850,000 divisé en 500 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSDLETS.Martel Express Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1951, constituant en corporation: Aldei Martel, camionneur, Armand Martel, comptable, et Gérard Ally, avocat, de Farnham, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Faire le transport, sous le nom de \"Martel Express Limitée\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.\"Le Comité des Chemins d'Hiver du Lac Sorcier\".The amount to which the immovable property which the corporation mav hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March* 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Lewis Brothers Asphalt Paving Limited Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirteenth day of March, 1951, incorporating: Jack Ackart Lewis, Roy William Lewis, contractors, of the Town of Mount-Royal, and Jeanne Drouin, secretary, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"Lewis Brothers Asphalt Paving Limited\", with a capital stock of 840,000.divided into 2,000 common shares of a par value of 810.each, and 200 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Make - Ur - Price Auto Sales Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951, incorporating: John Richard Hyde, Roland-Gerard Lcfrançpis, and Jean Jules Gadbois, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in automobiles and other motor vehicles, electrical apparatus and all accessories, operate garages, under the name of \"Make-Ur-Price Auto Sales Ltd.\", with a capital stock of 850,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1951.L.DÉSDLETS, 30137 Deputy Attorney General.Martel Express Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Qnebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, incorporating: Aldei Martel, carter, Armand Martel, accountant, and Gérard Ally, advocate, of Farnham, judicial district of Bedford, for the following purposes: To engage in the transportation business, under the name of \"Martel Express Limitée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1961, Vol.83, No.20 1501 Le siege soeial de la compagnie sera à Farn-ham, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.The head office of the company will be at Farnham, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Martin & Frères Limitée, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du seize mars 1951, constituant en corporation: Aimé Martin, Jean-Paul Martin, plâtriers, et Lionel Martin, comptable, tous de Rosemont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaire comme contracteurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Martin & Frères Limitée, Limited\", avec un capital de 810,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Merryn and Ogilvie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: Louis-P.Larivière, avocat, Harold Le-Hrock, comptable, et William Henry Johnston, gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'annonces et de publicité, sous le nom de \"Merryn and Ogilvie Inc.\", Le capital de la compagnie est divisé en 600 actions n'ayant pas de valeur nominale ou au pair; et le montant du capital avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $3,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté (lu bureau du Procureur général, ce vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Martin & Frères Limitée, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of March, 1951, incorporating: Aimé Martin, Jean-Paul Martin, plasterers, and Lionel Martin, accountant, all of Rosemount, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, undert he name of \"Martin & Frères Limitée, Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Merryn and Ogilvie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951., incorporating: Louis-P.Larivière, advocate, Harold LeBrock, accountant, and William Henry Johnston, manager, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on a general advertising and publicity business, under the name of \"Merryn and Ogilvie Inc.\", The capital stock of the company is divided into 600 shares having no nominal or par value: and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $3,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-first day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Metal Powders Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément â l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date \u2022lu douze mars 1951, constituant en corporation: John Herbert Legg, ingénieur en métallurgie, Georges Gouin, C R., avocat et Madeleine Dou-ect, sténographe, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de poudres de métal, en particulier des poudres de fer et d'acier et des poudres d'alliages de fer, sous le nom de \"Metal Powders Limited\", avec un capital de S40.000 divisé en en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Iberville, district judiciaire d'Iberville.Metal Powders Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 chapter 276, R.S.Q, 1941, bearing date the twelfth day of March, 1951, incorporating John Herbert Legg, metallurgical engineer, Georges Gouin, K.C., advocate, and Madeleine Doucet, stenographer, all of the City and Judicial District of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in metal powders, mainly iron and steel powders and iron alloy powders, under the name of \"Metal Powders Limited, with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Iberville, Judicial District of Iberville. 1502 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 88, N° 20 Daté du bureau du Procureur général, le douze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Playgirl Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept mars 1951, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, avocat, de la cité d'Outremont, Samuel Greenblatt, avocat, et Sonya Schneyer, secrétaire, tous de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce sous toutes ses formes, de vêtements de sport pour dames, sous le nom de \"Playgirl Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Playgirl Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act,'letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of March, 1951, incorporating: Cyril E.Schwisberg, advocate, of the City of Outre-mont, Samuel Greenblatt, advocate, and Sonya Schneyer, secretary, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in and with all manners and types of ladies' sportswear, under the name of \"Playgirl Inc.\", with a capital stock of $20,000.divided into 100 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Prudential Garage Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-sept mars 1951, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, Clifford George Meek, teneur de livres, et Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un ou des garages sous le nom de \"Prudential Garage Limited\", Le capital de la compagnie consistera en 1,000 actions sans valeur nominale ou au pair; et le montant avec lequel la compagnie transigera ses affaires ne sera pas moins de $5,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur-général, ce vingt-sept mars 1951.L'Assistant-procureur général.30137 L.DESKJETS.Quality Fur Dyeing (Canada) Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: June Kirlin, Sylvia Rabinovitch, Mavis Grant et Marie-Paule Hudon, secrétaires, filles majeures, toutes des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme teinturiers et apprêteurs de fourrures, manufacturer et faire le commerce de fourrures, peaux vertes, peaux brutes et cuirs, sous le nom de \"Quality Fur Dyeing (Canada) Corp.\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Prudential Garage Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-seventh day of March, 1951, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, Clifford George Meek, bookkeeper, and Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate a garage or garages, under the name of \"Prudential Garage Limited\", The capital stock of the company shall consist of 1,000 shares without nominal or par value; and the amount with which the company will carry on its business shall be not less than $5,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-seventh day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Quality Fur Dyeing (Canada) Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951, incorporating: June Kirlin, Sylvia Rabinotvitch, Mavis Grant and Marie-Paule Hudon, secretaries, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of fur dyers and dressers, to manufacture and deal in furs, skins, hides and leathers, under the name of \"Quality Fur Dyeing (Canada) Corp.\", with a capital stock of $10,000.divided into 1,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1951.L.DÉSDLETS, 30137-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.20 1503 Ranger Motors Sales Jjjj6 Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes,** en date du vingt-deux mars 1951, constituant en corporation: Emé Lacroix, avocat, et conseil en Loi du Roi.de Ville Mont-Royal, Jacques Viau, avocat, de Lachine, et Jacqueline Matte, sténographe, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre tout appareil de distribution de gazoline, pétrole et lubrifiant, gérer, exploiter des entrepôts, garages ou autres places semblables, sous le nom de \"Ranger Motors Sales Ltée, Ltd.\", avec un capital de §60,000 divisé en 600 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Ranger Motors Sales Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of March, 1951, incorporating: Emé Lacroix, advocate and King's Counsel, of the Town of Mount Royal, Jacques Viau, advocate, of Lachine, and Jacqueline Matte, stenographer, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, purchase, sell any apparatus for distribution of gasoline, petroleum and lubricants, manage, operate warehouses, garages or other similar premises, under the name of \"Ranger Motors Sales Ltée, Ltd.\", with a stock of $60,000 divided into 600 shares of $100 each.The head office of the company will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Redgemont Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du 9 mars 1951, constituant en corporation: Kenneth Albert Wilson, John McGlinchey Home, avocats et conseillers en Loi du Roi, et Kenneth Hunter Wilson, avocat, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placement sous le nom de \"Redgemont Corporation Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 5(1,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce 9 mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Redgemont Corporation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Licutenant-Govecnor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of March, 1951.incorporating : Kenneth Albert Wilson, John McGlinchey Home, advocates and King's Counsels, and Kenneth Hunter Wilson, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Redgemont Corporation Limited\", with a capital stock of $50,000 divided into 50,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Roscfrede Furs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: Abraham M.Kle>n, avocat, Harry Lyon Aronovitch, avocat et Freda Pomcrance, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et distributeurs de toutes sortes de fourrures et de toutes sortes de marchandises connexes au commerce des fourrures, sous le nom de \"Roscfrede Furs Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Rosefredc Furs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951, incorporating: Abraham M.Klein, advocate, Harry Lyon Aronovitch, advocate, and Freda Pomcrance, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dca'ers and distributors of all kinds of furs and all kinds of merchandise associated with the fur business under the name of \"Roscfrede Furs Ltd.\", with a capital stock of $20,000.divided into 200 shares of §100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General. 1504 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 Rouyn Metal Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M Alfred Morisset, conformément à l'article 2 chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: Georges Gagnon, homme d'affaires, Irving Kroch et Werner Daltrop, hommes d'affaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous les métaux ferrugineux ou non-ferrugineux, les fondre et raffiner, et faire le commerce de toutes sortes de matériaux et ferrailles utilisables, sous le nom de \"Rouyn Metal Corporation\", avec un capital de $50,000 divisé en 10,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1951.L'Ass stant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Royal Potato Chips, gjgj Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1951, constituant en corporation : Lucien Bélanger, comptable, de Sherbrooke, François-Arthur * Dion, hôtelier, et Wilfrid Laroche, entrepreneur, tous deux de Magog, tous du district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits alimentaires, produits laitiers, viandes, produits de la viande patates, produits de la patate, poisson, produits du poisson, sous le nom de \"Royal Potato Chips, Limitée\u2014Limited\", avec un capital de $70,000 divisé en 350 action ordinaires de $100 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Magog, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.St-Pierre Garage Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du neuf mars 1951, constituant en corporation: André Martin, avocat, de Westmount, Jean-Paul Lavallée, avocat, de la cité de Montréal, et Gisèle Dagenais, secrétaire, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: ' Faire affaire comme garagiste, sous le nom de \"St-Pierre Garage Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-b L.DÉSILETS.Rouyn Metal Corporation Notice is hereby given that under part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: Georges Gagnon, businessman, Irving Kroch and Werner Daltrop, businessmen, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in all metals, ferrous or non-ferrous, smelt and refine same, deal in all kinds of usable and scrap materials, under the name of \"Rouyn Metal Corporation\", with a capital stock of $50,000.divided into 10,000 shares of $5.each.The head office of the Company will he at Noranda, Judicial District of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney-Genera!, this ninth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Royal Potato Chips, ]A.m\\lt6c.¦ Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, incorporating: Lucien Bélanger, accountant, of Sherbrooke, François Arthur Dion, hotel keeper, and Wilfrid Laroche, contractor, both of Magog, all of the judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To deal in food products, dairy products, meats, meat products, potatoes, potato products, fish, fish products, under the name of \"Royal Potato Chips, Limitée\u2014Limited\", with a capital stock of $70,000 divided into 350 common shares of'$100 each and 350 preferred shares of $101) each.The head office of the company will be at Magog, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.St-Pierre Garage Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, hearing date the ninth day of March, 1951, incorporating: André Martin, advocate of Westmount, Jean-Paul Lavallée, advocate, of the city of Montreal, and Gisèle Dagenais, secretary, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, under the name of \"St-Pierre Garage Limitée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.20 1505 S.R.Wolff Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première par\" tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf mars 1951, constituant en corporation: Siegmund Robert Wolff, marchand, Lotte Alice Apolant, épouse séparée de biens de Siegmund Robert Wolff, et Dr Ruth Wolff, médecin, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce des produits chimiques de toutes sortes et de toute description sous le nom de \"S.It.Wolff Corp.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune, et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-neuf mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.S.R.Wolff Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1951, incorporating: Siegmund Robert Wolff, merchant, Lotte Alice Apolant, wife separate as to property of Siegmund Robert Wolff, and Dr Ruth Wolff, physician, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds and description of metals and chemicals, under the name of \"S.R.Wolff Corp.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1951.L DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.The Potters' Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze mars 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Mme Howard Keid, Mme A.Hawthorne, Mme J.Stcevcs, Mme Grace Pickering, Mme Lillian Cunningham, Mme G.Smart, toutes six ménagères et dûment autorisées par leur époux, Mademoiselle Jean Hawthorne, gérante de studio, Mademoiselle Florence Buckler, secrétaire-archiviste, Mme Agnès Gordon et Mme S.Prichard, toutes deux ménagères séparées légalement, et Mme E.All-press, ménagère, veuve, toutes des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Etudier et promouvoir la science de la poterie et de la céramique et entreprendre toutes activités utiles à ces fins, sous le nom de \"The Potters' Inc.\" Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Town House Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze mars 1951, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat et Conseil en Loi du Roi, de la cité de Westmount, Murray Sperber, avocat et Conseil en Loi du Roi, de Westmount, Murray Lapin, avocat, et Anne I.ash, secrétaire, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, boulangers, bouchers, épiciers, sous le nom de \"Town House Inc.\" avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.The Potters' Inc.Notice is hereby given that under the Provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date, the fifteenth day of March, 1951, incorporating: without share capital: Mrs Howard Reid, Mrs.A.Hawthorne, Mrs.J.Steeves, Mrs.Grace Pickering, Mrs Lillian Cunningham, Mrs.G.Smart, all six housewives, duly authorized by their husband, Miss Jean Hawthorne, studio manager, Miss Florence Buckler, recording secretary, Mrs Agnes Gordon and Mrs S.Prichard, both housewives, legally separated, and Mrs E.Allpress, house-wive and widow, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To study and promote the science of pottery and ceramics and to engage in any activities useful for such purposes, under the name of \"The Potters' Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Town House Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of March, 1951, incorporating: Marcus Meyer Sperber, advocate and King's Counsel, of the City of Westmount, Murray Lapin, advocate, and Anne Lash, secretary, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, bakers, butchers, grocers, under the name of \"Town House Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of the par value of $100 each, and 200 common shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal. 1506 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome.S3, N° 20 Daté du bureau du Procureur général le quatorze mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137 L.DÉSILETS.Transport Décarie Limitée Decarie Transport Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en (late du douze mars 1951, constituant en corporation: Yvon Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau et Rita Dufresnc, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: \u2022 Conduire et exploiter sous toutes ses formes que ce soit une entreprise de transport, le voitu-rage des produits, matériaux, marchandises, articles, effets ou bagages, sous le nom de \"Transport Décarie Limitée\"\u2014\"Décarie Transport Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 800 actions communes de S5 chacune et en 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le douze mars 1951.L'Assistant-procureur général.30137-o L.DÉSILETS.Yamaska Villiard Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1951, constituant en corporation: Paul-Êmile Villiard, commis, Armand Villiard, contracteur, et Dame Yvonne Pelletier Villiard.' épouse séparée de biens d'Armand Villiard, tous d'Yamaska, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Faire et exercer tous et aucun des commerces ermme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Yamaska Villiard Construction Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Yamaska Ouest, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1951.L'Assistant-procureur général, 30137-o L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137-o Deputy Attorney General.Transport Décarie Limitée Decarie Transport Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of March, 1951, incorporating: Yvon Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau and Rita Dufresnc, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To conduct and operate a transportation business in all lines of same; engage in the cartage of products, materials, merchandise, articles, effects or baggage, under the name of \"Transport Décarie Limitée\"\u2014\"Decarie Transport Limited\", with a capital stock of $-10,000 divided into 800 common shares of $5 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Yamaska Villiard Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1951, incorporating: Paul Emile Villiard, clerk, Armand Villiard, contractor, and Dame Yvonne Pelletier Villiard, wife separate as to property of Armand Villiard, all of Yamaska, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To engage in and carry on all and any business as general contractors, under the name of \"Yamaska Villiard Construction Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Yamaska West, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twenty first dav of March, 1951.L.DÉSILETS, 30137 Deputy Attorney General.Action en séparation de biens Action for separation as to property Province de Québec, district de St.Hyacinthe, Province of Quebec, district of Saint Hyacin- Cour supérieure, N° 6977.Dame Éloise Pépin, the, Superior Court, No.6977.Dame Éloise des cité et district de St-Hyacinthc, épouse Pépin, of the city and district of St.Hyacinthe, en biens de Willie Désilcts, conducteur d'autobus, wife common as to property of Willie Désilcts, des mêmes lieux demanderesse vs ledit Willie autobus driver, of the same place, plaintiff; va Désilcts, défendeur.the said Willie Désilcts, defendant.Une action en séparation de biens a été insti- An action for separation as to property was tuée en cette cause le 16ième jour de mai 1951 instituted in this case on the 16th day of May.1951.St.Hyacinthe, ce 16 mai 1951.St.Hyacinthe, May 16, 1951.Le Procureur de la demanderesse, P.POTHIER, 30172-o P.POTHIER, 30172 Attorney for the plaintiff. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.S3, No.20 1507 Arrêté en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 497 Québec, le 15 mai 1951.Présent : Le Lieutenant-gouverneur-cn-Conseil Concernant le permis de circulations sur les terres de la Couronne, entre le 19 mai et le 15 novembre 1951.Attendu que pour assurer la protection des bois contre le feu, il convient de mettre en force l'article 144 de la Loi «les Terres et Forêts, (Statuts Refondus 1941, chapitre 93) concernant le permis de circulation, l'expérience ayant démontré l'efficacité de cette mesure.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Terres et Forêts : Que tous ceux qui voudront pénétrer en forêt pendant la période entre le 19 mai et le 15 novembre de l'année 1951, devront au préalable se munir d'un permis de circulation tel que requis par l'article 144 de la Loi des Terres et Forêts (S.R.Q.1941, chap.93) et le montrer à tout garde-feu qui l'exigera.* A.MORISSET, 30159-o Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers St.Onge & Fournier Inc.Extrait du règlement N° 0 de la compagnie ci-haut mentionnée, concernant la réduction du nombre de ses directeurs de,cinq à trois: Sur proposition de M.Emile St.Onge, il est résolu à l'unanimité, par le présent règlement, portant le N° 6, que le nombre des directeurs de la compagnie soit réduit à trois.\" Copie certifiée.Le Président.J.-A.FOURNIER.La Secrétaire, 30139-o MARIA ST-ONGE-FOURNIER.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association of Employees of Standard Felt Products Limited\u2014Association des Employés de Standard Felt Products Limitée\", pour l'étude la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province en date du10 mai 1951.Le siège social dudit syndicat professionnel est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la Province, 30151 JEAN BRUCHÉSI.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le dix mai 1951, les règlements du \"Club Automobile Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 497 Quebec, May 15, 1951.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning travel permits on Crown Lands between May 19th and November 15th, 1951.Whereas to assure the protection of the forests against fire, it is deemed expedient to put into force section 144 of the Lands and Forests Act (Revised Statutes, 1941, chapter 93), concerning travel permits experience, having proved the efficacy of this measure.It is consequently ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Lands and Forests : That all those wishing to enter the forests between the 19th of May and the 15th of November of the year 1951, must previously obtain a travel permit as required by section 144 of the Lands and Forests Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 93) and show the said permit to any fire-warden when requested to do so.A.MORISSET, 30159 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices St.Onge & Fournier Inc.Excerpt from By-law No.6 of the above-mentioned company, concerning the decrease of the number of its Directors from five to three.\"Upon its being moved by Mr.Emile St.Onge.it was unanimously resolved, by the present By-Law, bearing No.G, that the number of directors be decreased to three.\" Certified Copy J.A.FOURNIER, President.MARIA ST-ONGE-FOURNIER, 30139 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association, under the name of \"Association of Employees of Standard Felt Products Limited\u2014Association des Employés de Standard Felt Products Limitée\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 10th, 1951.The principal place of business of the said Professional syndicate is at Montreal, in the judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI, 30151-o Under-Secretary of the Province.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the by-laws of the \"Club Automobile Beauce-Dorchester Inc.\", as adopted at the special 1508 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 Beauce-Dorchester Inc.\", tels qu'adoptés à l'assemblée générale spéciale tenue le 6 mars 1951, et ce, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi des clubs de récréation et de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 12 mai 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30153-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 16 mai 1951, les règlements de \"Verdun Police and Firemen's Amateur Athletic Association\", tels qu'adoptés à l'assemblée régulière tenue le 6 mai 1951, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 16 mai 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30161-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu l'un des triplicata de la déclaration de fondation de la \"Coopérative d'Électricité du Comté de Matane\", en date du quatorze mai 1951, dont le siège social est situé à Saint-Adelme, comté de Matane, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi de l'électrification rurale (9 George VI, chapitre 48).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le seize mai 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30162-o JEAN BRUCHÉSI.general meeting held on the 6th day of March, 1951, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on the tenth day of May, 1951, pursuant to the provisions of section 8 of the Amusement Clubs Act, and section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office«of the Provincial Secretarv, this 12th dav of May 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30153 Under Secretary of the Province.Notice is given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the by-laws of \"Verdun Police and Firemen's Amateur Athletic Association\", as adopted at a meeting duly held on the 6th day of May, 1951, were approved by the Honourable the Piovincial Secretary on the 16th day of May, 1951, pursuant to the piov-isions of section 225 of the Quebec Companies Act (R.S.Q., 1941, chapter 276).Given at the effi-e of the Provincial Secretarv, this 16th day of May, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30161 \" Under Secretary of the Province.Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received one of the triplicates of the declaration of foundation of the \"Coopérative d'Électricité du Comté de Matane\", dated the fourteenth day of May, 1951, whereof the head office is situate at Saint-Adelme, county of Matane, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 22 of the Rural Electrification'Act (9 George VI, chapter 48).Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth day of Mav, 1951.JEAN BRUCHÉSI.30162 Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 14 mai 1951, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"L'Association Canadienne des Travailleurs du Ciment, Local N° 1\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 16 mai 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30162-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 14 mai 1951, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"La Ligue Patronale des Boulangers Indépendants\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 16 mai 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 30162-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of May 14, 1951, enacted the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"L'Association Canadienne des Travailleurs du Ciment, Local N° 1\", and such in conformity with the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.194.1, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretarv, May 16, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30162 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professionnal Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of May 14, 1951, enacted the termination of the corporate existence of the professionnal syndicate \" La Ligue Patronale des Boulangers Indépendants\" and such in conformity with the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary.May 16,1951.JEAN BRUCHÉSI, 30162 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.SO 1509 AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné cpie l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 14 mai 1951, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Union of the Employees of Mack Trucks of Canada Limited\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 16 mai 1951.Le Sous-secrétaire de la Province, 301G2-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat National des Employés du Veneer de Si-Léonard\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-six avril 1951.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Léonard, comté de Nicolet.Le sous-secrétaire de la Province, 30166-o JEAN BRUCHÉSI.Bbvcouiit Gold Mixes Limited (Libre de responsabilité personnelle) Règlement trois-A 1.Le nombre des directeurs est.par les présentes, augmenté de cinq (5) à sept (7).2.L'article 1 du règlement trois est amendé en rayant le mot \"cinq\" et en y substituant le mot \"'sept\".Montréal.P.Q.4 mai 1951.Certifié vraie copie.(Sceau) L'Assistant-secrétaire, 30173 E.W.MOCKRIDGE.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has enacted ,on the 14th of May, 1951, the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Union of the Employees of Mack Trucks of Canada Limited\", and such, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this 16th day of May, 1951.JEAN BRUCHÉSI, 30162 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat National des Employés du Veneer de St-Léonard\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on April twenty-sixth, 1951.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Léonard, county of Nicolet.JEAN BRUCHÉSI, 30166 Under Secretary of the Province.Bevcouht Gold Mixes Limited (No Personal Liability) By-Law Three-A 1.The Board of Directors is hereby increased from five (5) to seven (7).2.Article 1 of By-law Three is amended by deleting the word \"five\" and substituting therefor the word \"seven\".Montreal, P.Q., May 4th.1951.Certified true copy.(Seal) E.W.MOCKRIDGE.30173-o Assistant-Secretary.Chartes \u2014 Abandon de AVIS LEGAL Avis est par les présentes donné que \"Albert Gauthier Inc.\", demandera permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi des compagnies de Qué- l>ec.Montréal, le 10 mai 1951.Le Président, 30144-o ALBERT GAUTHIER.AVIS LÉGAL Charters \u2014 Surrender of LEGAL NOTICE Notice is hereby given that the company \"Albert Gauthier Inc.\", will apply for leave to surrender its charter pursuant to the provisions of section 26 of the Quebec Companies Act.Montreal, May 10, 1951.ALBERT GAUTHD3R, 30144 President.LEGAL NOTICE Avis est par les présentes donné que \"Cie- Notice is hereby given that the company \"Clement's Market Limited\", demandera permission ment's Market Limited\", will apply for leave to d'abandonner sa charte conformément aux dispo- surrender its charter pursuant to the provisions sit ions de l'article 26 de la Loi des compagnies de of section 26 of the Quebec Companies Act.Québec.Montréal, le 10 mai 1951.Montreal, Mav 10, 1951.Le Président, LEOPOLD CLÉMENT, 30145k» .LEOPOLD CLÉMENT.30145 President. 1510 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 ' AVIS LÉGAL Avis est par les présentes donné que \"j.F.Ro-billard Inc.\", demandera permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi des compagnies de Québec.Montréal, le 10 mai 1951.Le Président, 30146-o j.F.ROBILLARD.United Converters Inc.Avis est donné que la compagnie \"United Converters Inc.\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, le 7 mai 1951.Le Secrétaire, 30149 HYMAN VINOKUR.Mont Tremulant Resorts Limited Avis est donné que la compagnie \"Mont Tremblant Resorts Limited\", demandera la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 10 mai 1951.Le Secrétaire, 30150 C.B.COOKE.Avis est par les présentes donné que \"Teen-O-Miss Inc.\", ayant son bureau-chef dans la cité et le district de Montréal, s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec pour obtenir la permission' d'abandonner ses lettres patentes, à partir de et après la date qu'il lui plaira de déterminer.Daté à Montréal de 15e jour de mai, 1951.Les Procureurs du Pétitionnaire, STEIN & STEIN.1435, rue St.Alexandre Ch.1075.Montréal, Que.30154-o LEGAL NOTICE Notice is hereby given that the company \"J.F.Robillard Inc.\", will apply for leave to surrender its charter pursuant to the provisions of section 26 of the Quebec Companies Act.Montreal, May 10, 1951.J.F.ROBILLARD, 30146 President.United Converters Inc.Notice is hereby given that \"United Converters Inc.\", incorporated under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its Charter under the Provisions of the Quebec Companies' Act.\u2022 Dated at Montreal, this 7th day of May, 1951.HYMAN VINOKUR, 30149-o .Secretary' Mont Tremblant Resorts Limited Notice is hereby given that \"Mont Tremblant Resorts Limited\" will make application for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 10th day of May, 1951.C.B.COOKE, 30150-o Secretary.Notice is hereby given that \"Teen-O-Miss Inc.\", having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Honourable Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, for leave to surrender its Letters Patent, from and after the date which he will be pleased to determine.Dated at Montreal, this 15th day of May, 1951.STEIN & STEIN, Attorneys for Petitioner.1435 St.Alexander Street, Suite 1075, Montreal.30154-o Compagnie dissoute Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu aux procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Canadian and Foreign Investors Limited\", constitué en corporation par lettres patentes en date du 21 juin 1929.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 mai 1951, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du procureur général, ce 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30163 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée Company Dissolved Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the Charter of the company \"Canadian and Foreign Investors Limited\", incorporated by letters patent dated the 21st day of June, 1929.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1951.L.DÉSILETS, 30163-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol 88, No.20 1511 par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Costume Regional Inc.\u2014Regional Costume Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date «lu 25 février 1946.Avis est de plus donne qu'à compter du quinze mai 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30163-0 L.DÉSILETS.the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Costume Régional, Inc.\u2014 Regional Costume, Inc.\" incorporated by letters patent dated the 25th day of February, 1946.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this 16th day of May, 1951.t L.DÉSILETS, 30163 Deputy Attorney General.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Highland Ski Tows Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date «lu 7 février 1941.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 mai 1951, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30163 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de \"La Compagnie de Distribution Électrique de Témiscouata Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 août 1933.Avis est «le plus donné qu'à compter du quinze mai 1951.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30163-o L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Highland Ski Tows Limited\", incorporated by letters patent dated the 7th day of February, 1941.Notice is also that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1951.L.DÉSILETS, 30163-0 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Compagnie de Distribution Électrique de Témiscouata Limitée\" incorporated by letters patent on August 22, 1933.Notice is also hereby given that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said company has been dissolved.Datc«l at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1951.L.DÉSILETS, 30163 Deputy Attorney General.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu \u2022le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte «le la compagnie \"Marwcst Trading & Holdings Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 27 juin 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 mai 1951 ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30163 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"New Select Restaurant Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 juillet 1946.Notice is hereby given that under Part I of the Quelle Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subjd t to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been placsed to accept the surrender of the charter of the company \"Marwest Trading & Holdings Limited\", incorporated by letters patent dated the 27th day of June 1945.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1951.L.DÉSILETS, 30163-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacte«l by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"New Select Restaurant Inc.\", incorporated by letters patent dated the 8th day of July, 1946. 1512 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 viai 1951, Tome 83, N° 20 Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mai 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30103-O L.DÉSILETS.Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276.article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"South Ccntremaque Gold Mines Limited\" (No Personal Liability), constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 mai 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze mai 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 mai 1951.L'Assistant -fi ocurcur général, 30163-O L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1911, et sujet à 'a responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Wigwam Leather Goods Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 mais 1936.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 mai 1951, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du Procureur général, de 16 mai 1951.L'Assistant-procureur général, 30163 L.DÉSILETS.Département de l'Instruction publique Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attornev General, this 16th dav of Mav, 1951.L.DÉSILETS, 39163 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to .accept the surrender of the charter of the company \"South Centremaque Gold Mines Limited\" (Mo Personal Liability), incorporated by letters patent dated the 25th day of May, 1945.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1951, he said company has been dissolved.Dated at the office of the Attornev General, this 16th dav of Mav, 1951.L.DÉSILETS, 30163 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrencer of the charter of the company \"Wigwam Leather Goods Inc.\", in-corporated by letters patent dated the 3rd dav of March 1936.Notice is also given that from and after the fifteenth day of May, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attornev General the 16th day of May, 1951.L.DÉSILETS, 31063-O Deputy Attorney General.Départirent of Education 7, mai 1951.Demande est faite d'annexer, pour les protestants seulement et pour toutes fins des écoles protestantes, les municipalités scolaires de Ayl-win N° 2 ,dans le comté de Gatineau, et Alleyn, dans le comté de Pontiac, à la municipalité scolaire de Aylwin N° 1, dans le comté de Gatineau, et d'ériger le territoire qui est décrit ci-dessous et lequel comprend le territoire de ces trois municipalités, en une municipalité scolaire séparée et distincte pour les protestants seulement sous le nom de \"Municipalité scolaire protestante de Aylwin\", dans le comté de Gatineau.Le territoire de cette nouvelle municipalité projetée est décrit comme suit: \"a) Tout le canton de Aylwin, dans le comté de Gatineau, borné au nord par le canton de Northfield, à l'est par la rivière Gatineau, au sud par le canton de Low et à l'ouest par le canton de Alleyn.b) Dans le canton de Alleyn, dans le comté de Pontiac, Dans les rangs I et H, les lots 1 à 12 inclusivement.Dans les rangs m, TV, V et VI, les lots 1 à 25 inclusivement.Cette section (b) est bornée au nord par la rivière Pickanoc Le Surintendant de l'Instruction publique, 30105-19-2 O.J.DÊSAULNIERS.May 7th, 1951.Application is made to annex for Protestants only and for all Protestant school purposes the school municipalities of Aylwin No.2, in the County of Gatineau, and Alleyn, in the County of Pontiac, to the school municipality of Aylwin No.1, in the County of Gatineau, and to erect the territory which is described below, and which includes the territory of these three municipalities, into a separate and distinct school municipality for Protestants only under the name of the \"Protestant School Municipality of Aylwin, in the County of Gatineau\".The territory of this proposed new municipality is described as follows: \"a) All the Township of Aylwin, in the County of Gatineau, bounded on the north by the Township of Northfield, on the east by the Gatineau River, on the south by the Township of Low and on the west by the Township of Alleyn.6) In the Township of Alleyn, in the County of Pontiac, In Ranges I and II, lots 1 to 12, inclusive, In Ranges DJ, IV, V and VI, lots 1 to 25, inclusive.This section (6) is bounded on the north by the Pickanoc River.\" O.J.DÊSAULNIERS, 30105-19-2-o Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.SO 1513 N° 456-51.Québec, le 1er mai 1951.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Wright, dans le comté de Gatineau, les lots 49 à 58 inclusivement des rangs VIII et IX du canton de Wright, et de les annexer à la municipalité scolaire de Blue-Sea-Lake, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.30085-19-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 508-51.Québec, le 2 mai 1951.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Chaudière, dans le comté de Lévis, en celui de \"Très-Saint-Rédempteur\", dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.30086-19-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 494-51.Québec, le 7 mai 1951.Demande est faite d'ériger en municipalité scolaire distrincte, sous le nom de \"Saint-Aimé-des-Lacs\", dans le comté de Charlevoix, le territoire ci-dessous décrit, savoir: Les lots suivants, tous inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Agnès, qui seront détachés de la municipalité scolaire de Sainte-Angès, dans le comté de Charlevoix, savoir: a) 213 à 250 de la concession du Ruisseau des Fresnes.b) 251, 251-A, 251-B, 252 à 268 de la deuxième concession du Ruisseau des Fresnes; c) 269 à 273 de la concession Ste-Catherine; d) 274 à 298 de la concession du lac Nairne; e) 299 à 354 de la première concession des Lacs; Les lots suivants, tous inclusivement, du cadastre officiel du canton De Sales, qui seront détachés de la municipalité scolaire de Notre-Dame-des-Monts, dans le comté de Charlevoix, savoir: a) 141 à 145 du rang IV (4); b) 340 à 345 et les subdivisions 1 à 18 inclusivement du lot 346; le lot 347 et les subdivisions l à 3 inclusivement du lot 348, tous du rang III (3) Est; c) 210 à 213 du rang II (2) Ouest; d) 226 à 246 du rang X (10); e) 247 à 264 du rang XI (11); f) 265 à 284 du rang XII (12); g) 285 à 316 du rang \"C\"; h) 317 à 320 du rang I Ouest; t) 349 à 370 du rang II (2) Est; j) 371 à 382 du rang \"A\"; k) 383 à 405 du rang \"B\"; Le Surintendant de l'Instruction publique.30104-19-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 925-50 7 mai 1951.Demande est faite, en vertu des dispositions de l'article 73 de la loi de l'Instruction publique, de détacher le territoire décrit ci-dessous de la municipalité scolaire de Ste-Anne de Bellevue, dans le comté de Jacques Cartier, et de l'annexer pour les protestants seulement et pour toutes fins des écoles protestantes, à la municipalité scolaire protestante \u2022 de Baie d'Urfé-Senneville, dans le même comté : Les lots P255 à 294, les lots 214 à 221 et la partie du lot 207-A qui est immédiatement à l'ouest des lots 214 à 221, tous les numéros inclusivement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 30106-19-2 O.J.DÊSAULNIERS.No.456-51 Quebec, May 1, 1951.Application is made to detach from the school municipality of Wright, in the county of Gatineau, lots 49 to 58 inclusively of ranges VIII and IX of the township of Wright, and to annex them to the School municipality of Blue-Sea-Lake, in the same county.O.J.DÊSAULNIERS, 30085-19-2 Superintendent of Education.No.508-51 Quebec, May 2, 1951.Application is made to change the name of the school municipality of Chaudière, in the county of Levis, into that of \"Très-Saint-Rédempteur\", in the same county.O.J.DÊSAULNIERS, 30086-19-2 Superintendent of Education.No.494-51 Quebec, May 7, 1951.Application is made to erect into a separate school municipality, under the name of \"Saint-Aimé-des-Lacs\", in the county of Charlevoix, the territory hercinbelow described, to wit: The following lots, all inclusively of the official cadastre for the ' parish of Sainte-Agnès, to be detached from the school municipality of Sainte-Agnès, in the county of Charlevoix, to wit: a) 213 to 250 of the \"Ruisseau des Fresnes\" concession; b) 251, 251-A, 251-B, 252 to 268 of the second \"Ruisseau des Fresnes Concession; c) 269 to 273 of the Stc-Catherine concession; d) 274 to 298 of the Lake Nairne concession; e) 299 to 354 of the first \"Concession des Lacs\" ; The following lots, all inclusively, of the official cadastre for the township»De Sales, to be detached from the school municipality of Notre-Dame-des-Monts, in the county of Charlevoix, to wit: a) 141 to 145 of range IV (4); b) 340 to 345 and subdivisions 1 to 18 inclusively of lot 346; lot 347 and subdivisions 1 to 3 inclusively of lot 348, all of range III (3) East; c) 210 to 213 range II (2) West; d) 226 to 246 of range X (10); e) 247 to 264 of range XI (11); /) 265 to 284 of range XII (12); g) 285 to 316 of range \"C\"; h) 317 to 320 of range I West; 0 349 to 370 of range II (2) East; j) 371 to 382 of range \"A\"; k) 383 to 405 of range \"B\"; O.J.DÊSAULNIERS, 30104-19-2 Superintendent of Education.No.925-50 May 7th, 1951.Application is made, under the provisions of Section 73 of the Education Act, to detach the territory described below from the school municipality of Ste.Anne de Bellevue, in the County of Jacques Cartier, and annex it, for Protestants only and for all Protestant school purposes, to the Protestant school municipality of Baie d'Urfé-Senneville, in the same County: Lots P225 to 294, lots 214 to 221, and the part of lot 207-A which is immediately west of lots 214 to 221, all numbers inclusive.O.J.DÊSAULNIERS, 30106-19-2-0 Superintendent of Education. 1514 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome 83, N° 20 .7 mai, 1951.May 7th, 1951.Demande est faite, en vertu des articles 72 Application is made, under Sections 72 and et 73 de la Loi de l'Instruction publique, de 73 of the Education Act, to detach from the détacher de la municipalité scolaire de St- school municipality of St.Etienne de Chelsea, Etienne de Chelsea, dans le comté de Gatineau, in the County of Gatineau, the following territory le territoire suivant et l'annexer à la munieipa- and annex it to the school municipality of lité scolaire de Cant ley, dans le même comté: Cantley, in the same County: La partie nord du lot 18, les lots 19 et 20 du Northern part of lot 18, lots 19 and 20 in rang XIV.Range XIV.Les lots 15a, 10, 17 et 18 du rang XV.Lots 15a, 16, 17, and 18 in Range XV.Les lots 18a, 20 et 21 du rang XVI.Lots 18a, 20 and 21 in Range XVI.Changement affectera les contribuables por- This change is to affect Protestant rate testants seulement.payers only.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.J.DÊSAULNIERS, 30107-19-2 O.J.DÊSAULNIERS.30107-19-2-o Superintendent of Education.7 mai 1951.May 7th, 1951.Demande est faite, en vertu des articles 72 Application is made, under Sections 72 and et 73 de la Loi de l'Instruction publique, «le déta- 73 of the Education Act, to detach from the cher «le la municipalité scolaire de St-Mathieu school municipality of St.Mathieu de Belceil, de Bclœil, dans le comté «le Verchères, le terri- in the County of Verchèrcs, the territory des- toire décrit ci-dessous et «le l'annexer, pour les cribed below and to annex it, for Protestants protestants seulement et pour toutes fins «les only and for ail Protestant school purposes, écoles protestantes, à la municipalité scolaire to the Protestant school municipality of Mc- protestante «le McMastcrville, dans le même Masterville, in the same County: comté: Le territoire comprend une partie des lots The territory comprises a part of original originaires 1, 2, 3, 4, 7.9, 10, 16, 18, 564, (Che- Lots 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 18, 564, (Canadian min de fer Canadien National) et le lot 15 du National Railway) and Lot 15 of the Official cadastre officiel de la paroisse «le St-Mathieu Cadastre of the Parish of St.Mathieu de Belceil, de Belceil et toutes leurs subdivisions présentes and all their present and future sub-divisions et futures et les limites «l'icelles, suivant ledit ami the limits whereof, referring to said Official cadastre officiel, sont décrits comme suit, à Cadastre, are described as follows, to wit: savoir : Partant «lu point «l'intersection «le la starting from the point of intersection of the S.ligne S.O.du lot 1 avec la ligne sud «lu lot 564 W.line of Lot 1 with the south line of lot 564 (emprise du Chemin «le fer Canadien National); (Canadian National Railway right of way); tie là, passant par les lignes et limites en conti- thence, passing by the following lines and bound-nuité les unes tics autres; le prolongement tic la aries, successively following each other; the exligne S.O.du lot 1 à travers ledit lot 564, ladite tension of the S.W.line of Lot 1 across the said ligne traversant le Boulevard Sir Wilfrid Lan- Lot 564, the sait! line crossing the Sir Wilfrid rier et continuant vers le N.O.jusqu'à un point Laurier Boulevard and continuing towards the partant à environ 550 pieds anglais du point N.W.to a point starting at about 550 English de départ; une ligne traversant les lots 1, 2, 3, 4, feet from the starting point; a line crossing lots et 7 passant par deux bornes établies sur le ter- 1, 2, 3, 4, ami 7 passing by two boundaries rain, une à l'intersection tie la ligne separative established on the land, one at the intersection des lots 2 et 3 et l'autre à l'intersection tic la of the dividing line of Lots 2 and 3 and the other ligne separative ties lots 4 et 7, jusqu'au coin at the intersection of the dividing line of Lots N.O.du lot originaire 9, une ligne brisée sépa- 4 and 7, to the N.W.corner of original Lot 9, rant les lots originaires 9, 10 et 15 d'un côté des a broken line dividing original Lots 9, 10 and lots originaires 11 et 14 de l'autre côté, au coin 15 on one side of original lots 11 and 14 from the nord dutlit lot 15, une ligne traversant les lots other side, to the Northern corner of said Lot originaires 16 et 18 dans une tlirection perpen- 15, a line crossing original Lots 16 and 18 in a diculaire aux lignes latérales s'étentlant au cen- perpendicular direction to the lateral lines, tre du chemin nommé Montée-dcs-Trcntcs, extending to the centre of the road called Mon-latlite Montée-des-Trentes et son prolongement tée-des-Trentes, the said Montée-des-Trentes, dans le Boulevard Sir Wilfritl Laurier sur une and its extension in Sir Wilfrid Laurier Boule-longueur de 2450 pieds anglais, ledit prolonge- vard on a length of 2450 English feet, the said ment continuant au côté sud de l'emprise du extension Continuing to the south side of the Chemin de fer Canadien National et enfin, Canadian National Railway right of way and ledit côté sud tie l'emprise du Chemin de fer finally, the said south side of the Canadian Na-Canadien National en allant vers l'ouest jus- tional Railway right of way, going toward the qu'au point de départ.West to the starting point.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.J.DÉSAULNEERS, 30108-19-2 O.J.DÊSAULNIERS.30108-19-2-c- Superintendent of Education.N° 371-51.No.371-51 Québec, le 14 mai 1951.Quebec, May 14, 1951.Demande est faite d'ériger en municipalité Application is made to erect into a separate scolaire distincte sous le nom de \"Hautcrive,\" school municipality under the name of \"Haute- dans le comté tie Saguenay, le territoire ci-des- rive\", in the county of Saguenay, the territory sous décrit, qui fait actuellement partie d'aucune hereindcr described, actually forming part of municipalité scolaire ) When the following holidays fall on a.work day and are not worked, they shall l>e paid at the regular rate of pay: Christmas Day.New Years' Day.Epiphany Day, St-Jean Baptiste Day and I.al)iiiii- Day.However, to be entitled to these holidays with pay, the employee whall work, or 1520 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1951, Tome S3, N° 20 disposition de son employeur la veille et le lendemain des dites fêtes.IX.Dispositions relatives aux jours chômés et aux vacances: a) Jours chômés: Les jours chômés pour les fins d'application du décret sont les suivants: Les dimanches, le Premier de l'An, l'Epiphanie, le Vendredi Saint jusqu'à midi, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, la Toussaint, l'Immaculée Conception et le jour de Noël.Toutefois, les employeurs ont la faculté de ne chômer que l'une ou l'autre des deux fêtes de la Saint-Jean-Baptiste ou de la Confédération.Aux salariés qui travaillent les jours de l'êtes religieuses, on doit faciliter l'accomplissement de leurs devoirs religieux.b) Vacances payées: i.Tout salarié régi par le décret qui, au 30 avril de chaque année, possède une année de services continus pour le même employeur ou dans le même établissement a droit à un congé annuel payé et continu d'une semaine.La date de tel congé est laissée à la discrétion de l'employeur à la condition, toutefois, que ledit congé soit octroyé dans les douze mois de la date à laquelle le droit à tel congé est acquis.ii.S'il n'a pas un an de services continus pour on employeur au moment du congé annuel, il a droit à un congé continu payé d'une durée minimum d'autant de demi-jours qu'il a de mois de calendrier de services continus pour cet employeur.iii.La durée des services continus doit s'entendre de la péiiode pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompu sans qu'il y ait résiliation de contrat.iv.Ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée des services continus, les jours de maladie, si le contrat n'a pas été résilié, les jouis de fermeture, les périodes de congé annuel, de délai-congé, les absences autorisées si le salarié n'a pas occupé pendant ces journées un autre emploi rémunéré.c) Rémunération: Le salarié a droit pour son congé à une rémunération équivalente: i.S'il est engagé et payé à la semaine ou pour une plus période, au salaire auquel il aurait droit s'il travaillait pendant les jours de travail de sa période de cpngé; ii.S'il est payé suivant un autre mode, à deux pour cent (2%) du salaire gagné durant, la période de services lui donnant droit à un tel congé.d) Échéance de la rémunération : Avant le départ du salarié visé par le paragraphe \"//' l'employeur doit lui payer sa rémunération pour ce congé.e) Période de prise de congé: Chaque congé doit être donné dans les douze mois de la date à laquelle le droit à tel congé est acquis./) Fixation de la période de congé: Le salarié a le droit de connaître au moins quinze (15) jours à l'avance la date de la période de congé.g) Congé obligatoire: Il est interdit à un employeur de remplacer pai une indemnité compensatrice le congé annuel payé prescrit par le décret.X.Dispositions relatives aux apprentis: a) Le nombre des apprentis (sexe masculin) ne doit pas dépasser 20% du total des préposés aux machines suivantes: marqueur-mitrailleuses, guillotine, monteuse simple et double, bobineuse, presse-cylindre à découper, presse à plateau à découper, machine automatique à coller, emporte-pièce, colleuse Brightwood, machine à renforts et machine à quatre coins.he at the disposal of his employer the day before and the day after such holidays.IX.Provisions respecting observed holidays and vacations: a) Observed holidays: Observed holidays, for the purposes of enforcement of the decree, shall be the following: Sunday, New Year's Day, Epiphany, Good Friday until noon.Ascension Day, St.John the Baptist Day, Do-minion Day, Labour Day.All Saints' Day.Immaculate Conception Day and Christmas Day.However, the employer may observe cither St.John the Baptist Day of Dominion Day.In the case of employees working on religious holidays steps should be taken to facilitate the carrying out of their religious duties.b) Vacation with pay: i.Every employee governed by the decree who.on April 30 of each year, has one year of continuous service for the same employer or in the same establishment is entitled to a continuous annual vacation with pay of one week.The date of such vacation shall be set by the employer providing, however, that the said vacation be given in the twelve months following the date on which the right to such vacation has been 'acquired.ii.When he has less than one year of continuous service for his employer at the time of the vacation, he is entitled to an annual continuous vacation with pay of at least as many half-days as he has calendar months of continuous service for his employer.iii.The duration of continuous service shall be the period during which the employee is bound by a labour contract with his employer, even if the earring out of the said contract has been interrupted without annulment thereof.iv.The duration of continuous service should not be considérée! as being interrupted especially in cases of illness, when the contract has not been annulled, of days of closing, of annual vacation periods, of terms of notice, of authorized absences, if, during these days, the employee has not done remunerated work.c) Remuneration: The employee is entitled, for his vacation, to a remuneration equivalent: i.if employed and paid by the week or a longer period, to the wages which he would have received if he had been working during his vacation period; ii.if paid on another basis, to two per cent (2%) of the wages earned during the period of service which entitles him to such vacation.d) Payment of vacation remuneration: The employees referred to in subsection \"6\" shall be given their vacation pay by their employer before they leave for said vacation.e) Period of vacation: Every vacation shall be given within the twelve months following the date on which the right to such vacation has been acquired./) Setting of vacation jreriod: Every employee shall know of the period of his vacation at least fifteen (15) days in advance.g) Compulsory vacation: No employer may replace by a compensating bonus the annual vacation with pay prescribed by the decree.X.Provisions respecting apprentices: a) The number of male apprentices shall not exceed 20% of the total number of the operators on the following machines': scorers, cutters on knife, end piece-single and double, slitter, cylinder box press.Plat in press, automatic glueing machine, punch Brightwood machine, staying machine, four-corner machine. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 19th, 1951, Vol.83, No.20 1521 h) Le nombre total des apprentis (sexe féminin no doit pas dépasser 20% du nombre total des préposées au paquetage et aux machines suivantes: machine \"Stokes & Smith\", machine à poser les dessus, machine à couvrir, machine à ionforls.machine à piquer, gommeuse filée à la main et machine Rcdingtou.\\I.Salait es des métiers de l'imprimerie: Les conditions de salaires de travail d'apprentissage des salariés, des métiers de l'imprimerie travaillant dans les établissements régis par le décret, sont les mêmes que celle déterminées dans le décret numéro 141, du S février 1951, relatif aux métiers de l'imprimerie dans la région 8c Québec, ou dans tout autre décret qui pourrait le remplacer à l'exception, toutefois, de la durée régulières de travail qui doit être de quarante-huit (48) heures par semaines.XII.Nonobstant les dispositions du présent décret, les pat ties s'engagent à signer une requête conjointe dans le but de reviser les taux minima ou de base dudit décret dans un délai de soixante ((50) jours de la publication dans la Gazette officielle de Québec de tout autre décret affectant la même industrie dans un autre centre de la Province, de façon que l'écart entre chacun des taux minima ou de base apparaissant au décret et chacun des taux minima ou de base fixés par Ici autre décret ne soient pas supérieurs à cinq pour cent (5%).Si cet autre décret contient des échelle de base n'apparaissant pas au décret, les parties*conviennent de les inclure dans kur requête en tenant compte de l'écart ci-haut mentionné.XIII.Le décret, dans les limites de sa juridiction territoriale, abroge et remplace le déeiet numéro 1133 du 1er septembre 1948 et amendement.XIV.Durée du décret: Le décret est valable à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et même en vigueur jusqu'au premier avril 1952.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins f reference for the township of Grantham, under numbers ninety-five and ninety-six of the official subdivision of the original lot number one hundred and thirty-six A (136/1-95 and 96), circumstances and dependencies.To be sold pursuant to a judgment of the Superior Court for the District of Arthabaska.sitting in bankruptcy, rendered on the twenty-fourth of April, nineteen hundred and fifty-one.bearing N° 74F of the records of the said Court, by public auction, so as to give to this sale the effect of a Sheriff's Sale pursuant, to the provisions of section forty-five of the Bankruptcy Act, at the Saint Frederic church
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.