Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 août 1951, samedi 4 (no 31)
[" Tome 83, N° 31 2117 Vol.83, No.31 \t\t _\t\t1 \t\tH *\t\tt Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14Ceo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Quebec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 4 août 1951 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1951.Québec, le 11 juin 1951.\"L'Imprimeur du Roi, 30325-24-11-o RÉDEMPTI PARADIS.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, August 4th, 1951 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1951.Quebec, this 11th of June 1951.RÉDEMPTI PARADIS, 30325-24-1 l-o King's Printer.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 2118 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 août 1051, Tome 83, N° 31 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazdtc officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur «lu Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.S0 Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 260 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.Là matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: §7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition tic la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u20141-52 the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the public lion of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u2014 1-52 Lettres patentes __i Aylmer Insurance Agency Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies île Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un juin 1951, constituant en corporation: Paul Daoust, courtier en assurance, Henri Mas-son, comptable agréé, et Marguerite Ste-Marie, Letters Patent Aylmer Insurance Agency J™r Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 19-11, bearing date the twenty-first day of June, 1951, incorporating: Paul Daoust, insurance broker, Henri Masson, chartered accountant, and Marguerite Ste-Marie, secretary, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, August Mh, 1951, Vol.S3, No.31 2119 secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Sujet aux dispositions de la Loi des assurance de Québec et de ses règlements, faire affaires com me courtiers en assurances, agents d'assurances- sous le nom de \"Aylmer Insurance Agency j^^»' avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions ordinaires de 850 chacune, et en 400 actions pri \u2022 vil'giées de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30G22-o C.E.CANTIN.Belle Construction Ltée Belle Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 27, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze juin 1951, constituant en corporation-: Jean-Marie Lcmay, négociant, d'Hébertville-Station, Marcel Bouchard, secrétaire et Roland Bergeron, avocat, de Roberval, tous du district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Belle Construction Ltée\" \u2014 \" Belle Construction Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hébert-ville-Station, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.E.CANTIN.all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Subject to the provisions of the Quebec Insurance Act and its regulations, to carry on business as insurance brokers and insurance agents, under the name of \"Aylmer Insurance Agency Ltd.\", Ltée\", with a capital stock of S40,000 divided into 400 common shares of §50 each, and 400 preferred shares of §50 each.\u2022 The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30022 Acting Deputy Attorney General.Belle Const rue I ion Ltée Belle Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of June, 1951, incorporating: Jean-Marie Lcmay, dealer, of Hébcrtville-Station, Marcel Bouchard, secretary, and Roland Bergeron, advocate, of Roberval, all of the judicial district of Roberval, for the following purposes: To act as general building contractors, under the name of \"Belle Construction Ltée\" \u2014 \"Belle Construction Ltd.\", with a capital stock of $40,-000 divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company will be at Hé-bertville-Station, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Columbus Textile Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du trente et un mai 1951, constituant en corporation: Maurice Langlois, Frank Ivan Ritchie, jr., avocats, et Jacqueline Gélinas, sténographe, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Faire le trafic, négocier et exercer le commerce qui consiste à manufacturer coton, laine, filé et autres substances fibreuses, soit naturelle ou synthétique, sous le nom de \"Columbus Textile Co.Ltd.\", avec un capital de S500.000 divisé en 2,500 actions priviligiées de 8100 chacune et 2,500 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mai 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.E.CANTIN.Cordia Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, Columbus Textile Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the thirty-first day of May, 1951, incorporating: Maurice Langlois, Frank Ivan Ritchie, jr., advocates, and Jacqueline Gélinas, stenographer, all of the city and judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To trade, deal in and carry on the business of manufacturing cotton, wool, worsted and other fibrous substances, natural or synthetic, under the name of \"Columbus Textile Co.Ltd.\", with a capital stock of S500.000 divided into 2,500 preferred shares of 8100 each and 2,500 common shares of S100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Jlivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of May, 1951.C.E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Cordia Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, 2120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, k août 1951, Terne 83, N° 31 S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du trente mai 1951, constituant en corporation: Eli Michœl Berger, avocat, Pearl Auerbach, Rhoda Cohen, secrétaires, et Irving Halperin, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter et diriger des garages et exercer le commerce général de livraison par automobile et celui de voituriers public et privé, sous le nom de \"Cordia Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.E.CANTIN.Desrochers & Wodon Ltée \u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze juin 1951, constituant en corporation: Dame J.Swibert Desrochers, commerçante, Maurice Desrochers, industriel, et Gaston Desrochers, commerçant, tous de Joliette, district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quincaillerie, de matériaux de construction de toutes sortes, accessoires de ménage, meubles de toutes sortes, sous le nom de \"Desrochers & Wodon Ltée\".Le capital-actions de la compagnie sera divisé en 390 actions privilégiées d'une valeur au pair ou nominale de $100 chacune, et en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair ou nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.E.CANTIN.Forest ville Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze juin 1951, constituant en corporation: Paul-Emile Langlois, Lucien Gobeil, comptables, et Pauline Gobeil, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchand d'automobiles et de garagiste, sous le nom de \"Forestville Automobiles Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Forestville, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général le quatorze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.E.CANTIN.Gelber David Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris- R.S.Q.1941, bearing date the thirtieth day of May, 1951, incorporating: Eli Michœl Berger, advocate, Pearl Auerbach, Rhoda Cohen, secretaries, and Irving Halperin, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate and manage garages, and to carry on generally the business of a motor car livery and that of public and private carriers, under, the name of \"Cordia Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieh day of May, 1951.C.E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Desrochers & Wodon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of June, 1951, incorporating: Dame J.Swibert Des-rochers, trader, Maurice Desrochers, industrialist, and Gaston Desrochers, trader, all of Joliette, judicial district of Joliette, for the following purposes: To deal in hardware, building requisites of all kinds, household effects and furniture of all kinds, under the name of \"Desrochers & Wodon Ltée\".The capital stock of the company to be divided into 390 preferred shares of a par or nominal value of $100 each, and into 100 common shares of a par or nominal value of $10 each.The head office of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Forestville Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of June, 1951, incorporating: Paul Emile Langlois, Lucien Gobeil, accountants, and Pauline Gobeil, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of automobiles dealer and garage keeper, under the name of \"Forestville Automobiles Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Forestville, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Gelber David Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 4th, 1951, Vol 83, No.31 2121 set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du cinq juin 1951, constituant en corporation: David Gelber, marchand, de Westmount, Mme Sadie Evin Gelber, épouse séparée de biens dudit David Gelber, de Westmount, district judiciaire de Montréal, et Sam Schwarz Bard, avocat, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeuble, sous le nom de \"Gelber David Realty Corporation\", avec un capital de $250,000 divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 20,000 actions priviligiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1117 ouest, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.E.CANTIN.Hardy & Rinfret Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quinze juin 1951, constituant en corporation: Paul-Emile Hardy, Edmond Rinfret et Maurice Vincent, tous marchands de fourrures, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie de la fourrure, sous le nom de \"Hardy & Rinfret Ltée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au numéro 1867, rue Amherst, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quinze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.E.CANTIN.James A.Wright & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze juin 1951, constituant en corporation: James Andrew Wright, peintre et préposé à l'entretien, Dame Jeanne Diana Guiliemette, épouse séparée de biens dudit James Andrew Wright, et Georges Henri Dureault, avocat, et Conseil en Loi du Roi, tous de la cité de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Exercer le commerce de décorateurs, peintres et dessinateurs, et vendeurs de toutes sortes de travaux décoratifs ou de peinture, sous, le nom de \"James A.Wright & Sons Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le 11 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.E.CANTIN.J.-W.Ouellet Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifth day of June, 1951, incorporating: David Gelber, merchant, of Westmount, Mrs.Sadie Evin Gelber, wife separate as to property of the said David Gelber, of Westmount, judicial district of Montreal, and Sam Schwarz Bard, advocate, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company under the name of \"Gelber David Realty Corporation\", with a capital stock of $250,000 divided into 5,000 common shares of a par value of $10 each, and 20,000 preferred shares at a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1117, Ste-Catherine West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.'Hardy & Rinfret Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of June, 1951, incorporating: Paul Emile Hardy, Edmond Rinfret, and Maurice Vincent, all fur merchants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the fur business, under the name of \"Hardy & Rinfret Ltée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at No.1867 Amherst street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.James A.Wright & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1951, incorporating: James Andrew Wright, painter and maintenance operator, Dame Jeanne Diana Guilmette, wife separated as to property of the said James Andrew Wright, and George-Henri Dureault, advocate and King's Counsel, all of the city of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To carry on business as decorators, painters and designers, and dealers in decorative and painting work of all kinds, under the name of \"James A.Wright & Sons Limited\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.J.-W.Ouellet Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been 2122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 août 1951, Tome S3, N° 31 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du treize juin 1951, constituant en corporation: J.-Wilfrid Ouellet, manufacturier, Léo Oucllet, horloger, et Cinum Oucllet, menuisier, tous de Saint-Hubert, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Manufacturer «les l.o.'tcs, des meubles et toutes marchandises en bois d'une manière générale, sous le nom de \"J.-W.Ouellet Ltée\", avec un capital de S25.000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hubert, district, judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le treize juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30G22-o C.E.CANTIN.Kirby Co.of Quebec Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit juin 1951, constituant en corporation: Monroe Abbey, Max Slapack et Gregory Charlap, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de machines à nettoyer par le vide, machinerie, moteurs, outils, instruments et quincaillerie de toutes sortes, sous le nom de \"Kirby Co.of Quebec Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune, et 390 actions priviligiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.E.CANTIN.La Compagnie Electrique de L'Ile aux Coudres Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le I ieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1951, constituant en corporation: Jean-Julien Fortin, ingénieur conseil, de Chi-coutimi, Henri Boulianne, contracteur électricien et plombier, et Elzéar Potvin, maître-électricien, tous deux d'Arvi.ia, tous du district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Fabriquer, transmettre, distribuer de toute manière quelconque, de l'électricité, du gaz ou toute autre source d'énergie, de force et de lu-mière, dans l.Tle-aux-Coudres, comté de Charlevoix, sous le nom de \"La Compagnie Electrique de LTlc-aux-Coudres\", avec un capital de $75,000 divisé en 400 actions ordinaires de SI00 chacune, et en 350 actions priviligiées'de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.E.CANTIN.issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of June, 1951, incorporating : J.Wilfrid Ouellet, manufacturer, Léo Ouellet, watchmaker, and Cimon Ouellet, joiner, all of Saint-Hubert, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To manufacture boxes, furniture and any merchandise in wood in general, under the name of \"J.-W.Ouellet Ltée\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Hubert, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Kirby Co.of Quebec Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of June, 1951, incorporating: Monroe Abbey, Max Slapack and Gregory Charlap, advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To Ranufacture and deal in vacuum cleaners, machinery, engines, tools, implements and hardware of all kinds, under the name of \"Kirby Co.of Quebec Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 1,000 common shares of $1 each, and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of June, 1951.^ C.E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.La Compagnie Electrique de L'Ile aux Coudres Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1951, incorporating: Jean Julien Fortin, consulting engineer, of Chicoutimi, Henri Boulianne, electrical contractor and plumber, and Elzéar Potvin, master electrician, both of Arvida, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture, transmit, distribute in any manner whatsoever, electricity, gas or any other source of power, force and light, in L'lle-au-Cou-drcs, county of Charlevoix, under the name of \"La Compagnie Electrique de LTle-aux-Coudres\" with a capital stock of $75,000 divided into 400 common shares of $100 each, and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.s Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.La Maison Française, Inc.La Maison Française, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies Act, letters patent have been QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 4th, 1941, Vol.S3, No.31 2123 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du cinq juin 1951, constituant en corporation: Claude Michel, agent, Taschereau Fortier, avocat, et Françoise Laperrière, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous articles et marchandises faits en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, métaloide, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et tous les sous-produits d'iceux, sous le nom de \"La Maison Française, Inc.\", avec un capital de 815,000 divisé en 1,500 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le cinq juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, ' 30G22-o C.E.CANTIN.Laporle & La mouche Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris-set, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du cinq juin 1951, constituant en corporation: Fernand Laporte, plombier, Hector Lainouche, plombier, et Arthur Lavoic, ferblantier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le métier de plombiers, couvreurs, entrepreneurs plombiers et couvreurs, sous le nom de \"Laporte & Lamouche Ltée\", avec un capital de 840,000 divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le cinq juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris-set, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the fifth day of June, 1951, incorporating: Claude Michel, agent, Taschereau Fortier, advocate, and Françoise Laperrière, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in all articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, metalloid, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and the by-products of same, under the name of \"La Maison Française, Inc.\", with a capital stock of $15,000 divided into 1,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30022 Acting Deputy Attorney General.Laporte & Lamouche Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-rissct, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifth day of June, 1951, incorporating: Fernand Laporte, plumber, Hector Lamouche, plumber, and Arthur Lavoie, tinsmith, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade of plumbers and roofers and that of plumbing and roofing contractors, under the name of \"Laporte & Lamouche Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of S10 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.La Revue Radio-Télévision Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941\", des lettres patentes, en date du deux juin 1951, constituant en corporation: Fernand Robidoux, artiste lyrique, Montréal, Marcel L'Archevêque, éditeur, Paul-H.Levesque, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Editer, publier, imprimer ou autrement disposer de revues, périodiques, journaux, dépliants, feuillets \"et fascicules, sous le nom de \"La Revue Radio-Télévision Inc.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 200 actions sans valeur au pair ou nominale et en 100 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $2,000.Le siège social de la corporation sera à Ville Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.La Revue Radio-Télévision Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the second day of June, 1951, incorporating :*Fernand Robidoux, lyric artist, Montreal, Marcel L'Archevêque, editor, Paul H.Levesque, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To edit publish, print or otherwise dispose of reviews, fascicles, periodicals, papers, folders, leaflets and fascicles, under the name of \"La Revue Radio-Télévision Inc.\", The capital stock of the company is divided into 200 shares without nominal or par value and into 100 preferred shares of 8100 each, and the amount with which the company will commence its operations is 82,000.The head office of the corporation will be at Ville Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of June, 1951, C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deguty Attorney General. 2124 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 août 1951, Tome 83, N° 81 Laurcntian Mining & Extraction Co.Ltd.Laurentian Mining & Extraction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première pat-tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes en date du neuf juin 1951, constituant en corporation: Jean Ouellette, avocat, de la cité de Montréal, Yvon Lefebvre, avocat, de la cité d'Outremont, et Maurice Ouellette, comptable agréé, résident de la ville de St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Conduire et exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Laurentian Mining & Extraction Co.Ltd.\", avec un capital de $10,00 divisé en 1.000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jovite, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30G22 C.-E.CANTIN.Leader Products Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du deux juin 1951, constituant en corporation: Maurice Charlebois, manufacturier, Yvon Bock, avocat, Jacqueline de Ladurantaye, sténographe, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et négociants de produits et matériaux, à l'état brut, semi-ouvrés ou finis, en fer, acier, cuivre et autres métaux et alliages de toutes sortes, de bois et de matières plastiques, sois le nom de Leader Products Company Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 95 ouest, rue St-Zotique, Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.Le Centre Recréatif de Ste-Claire Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze juin 1951, constituant en corporation safis capital-actions: Wilbrod Bherer, C.R., Jacques Juneau et Guy Pouliot, advocats, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Promouvoir, encourager, maintenir et développer l'exercice des sports en général et les activités sociales et récréatives pour les membres, sous le nom de \"Le Centre Recréatif de Ste-Claire\".Les pouvoirs accordés ne doivent pas être interprétés comme permettant les jeux à l'argent, les jeux de hasard ou les jeux mixtes de hasard ou d'habilité, les paris et ne permettent pas à la corporation de demander ou d'opérer une licence émise par la Commission des Liqueurs de Québec; Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $125,000.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1951, incorporating: Jean Ouellette, lawyer, of the City of Montreal, Yvon Lefbvre, lawyer, of the City of Outremont, and Maurice Ouellette, chartered accountant, residing in the ville Saint-Laurent, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of general contractors, under the name of \"Laurentian Mining & Extraction Co.Ltd.\", with a capital stock of 510,000, divides into 1,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Saint-Jovite, in the Judicial District of Terebonne Dated at the office of the Attorney General this ninth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Leader Products Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in confornity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the second day of June, 1951, incorporating: Maurice Charlebois, manufacturer, Yvon Bock, advocate, Jacqueline de Ladurantaye, stenographer, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers of and dealers in products and materials, in the raw, semi-wrought or finished state, in iron, steel, copper and other metals and alloys of all kinds, wood and plastic materials, under the name of \"Leader Products Company Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 95 St-Zotique street West, Montreal, judicial district of Montrreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Le Centre Recréatif de Ste-Claire Notice is heseby given that under Part du of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.,1941, bearing date the eleventh day of June, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Wilbrod Bherer, K.C., Jacques Juneau and Guy Pouliot, advocates, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To promote, encourage, maintain and develop the exercice of sports in general and social and recreational activities for the members, under the name of \"Le Centre Recréatif de St-Claire\".The powers conferred shall nor be interpreted as permitting gambling, games of chance or games of chance and skill mixed or betting, nor shall they permit the corporation to apply for or operate a licence issued by the Quebec Liquor Commission; The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $125,000. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 4th, 1941, Vol.83, No.31 2125 Le siège social de la corporation sera à Sainte-Claire district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le onze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.The head office of the corporation will be at Sainte-Claire, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Les Alliés de la Baie, Inc.Les Alliés de la Baie, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de Notice is hereby given that under Part HI of la troisième partie de la Loi des compagnies de the Companies Act, letters patent have been Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouver- issued by the Lieutenant-Governor of the Pro- neur de la province de Québec des lettres paten- vince of Quebec, bearing date the thirteenth day tes, en date du treize juin 1951, constituant en of June, 1951, to incorporate as a corporation corporation sans capital-actions: Léo Tanguay, without share capital: Léo Tanguay, physician, médecin, Léon Tremblay, agent, Amédé Trem- Léon Tremblay, agent, Amédé Tremblay, paper May, papetier, Céréal Ellefsen, électricien, Mau- maker, Céréal Ellefsen, electrician, Maurice rice Ellefsen, Frank Davies, comptables, Ellefsen, Frank Davies, accountants, Raymond Raymond Tremblay, livreur, Jean-Marie Trem- Tremblay, delivery-man, Jean Marie Tremblay, blay, contremaître, Joseph Haddad, marchand, foreman, Joseph Haddad, merchant, John John McLean, maître de poste, Léo Gilbert, McLean, post master, Léo Gilbert, clerk, Raoul commis, Raoul Brisson, livreur, René Fradette, Brisson, delivery-man, René Fradette, Antoine Antoine Boivin, Léon-Maurice Tremblay, com- Boivin, Léon Maurice Tremblay, clerks, and mis, et Jos-Eugène Tremblay, secrétaire-tréso- Jos-Eugène Tremblay secretary-treasurer, all rier, tous de Bagotville, district judiciaire de of Bagotville, judicial district of Chicoutimi, Chicoutimi, pour les objets suivants: for the following purposes: Organiser, promouvoir les parties et les con- To organize and promote hockey matches and cours de hockey, sous les nom de \"Les Alliés de competitions, under the name of \"Les Alliés de la Baie, Inc.\", la Baie, Inc.\" Les pouvoirs accordés ne permettent pas les The powers conferred do not permit games of jeux de hasard, à l'argent, d'habilité, les paris chance, gambling, games of akill or illegal betting, illégaux, et n'autorisent pas non plus la corpora- nor do they authorized the corporation to apply tion à demander, détenir ou exploiter une licence for, hold or operate a licence granted by the Que- octroyée par la Commission des Liqueurs de bec Liquor Commission; Québec; Le montant auquel sont limités les biens im- The amount to which the immovable property mobiliers que la corporation peut posséder, est which the corporation may hold is to be limited, de $10,000.is $10,000.Le siège social de la corporation sera à Bagot- The head office of the corporation will be at ville, district judiciaire de Chicoutimi.Bagotville, judicial district of Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le treize Dated at the office of the Attorney General, juin 1951.thi& thirteenth day of June, 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, C.-E.CANTIN, 30622-o C.-E.CANTIN.30622 Acting Deputy Attorney General.Metalco Limitée Metalco Limitée Metalco Limited Metalco Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Compagnies Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Province de Québec, représenté par M.Alfred Mo- vince of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, risset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day quatorze juin 1951, constituant en corporation: of June, 1951, incorporating: Jules Louis Dupuis, Jules-Louis Dupuis, industriel, de Eastman, dis- industrialist, of Eastman, judicial district of Bed-trict judiciaire de Bedford, Pierre-J.Chapuis, ford, Pierre J.Chapuis, Raymond Lefebvre, Raymond Lefebvre, Philias-A.Dionne, gérants, Philias A.Dionne, managers, Jean Lincqurt, Jean Lincourt, agent d'assurance, Adrien Mauri- insurance agent, Adrien Maurice, hotel-keeper, ce, hôtelier, Fernand St-Pierre, commis, Alfred Fernand St-Pierre, clerk, Alfred Marcoux, carter, Marcoux, camionneur, Madeleine-E.Dupuis, Madeleine E.Dupuis, manager, Robert Trudel, gérante, Robert Trudel, comptable, et Roger accountant, and Roger Bouchard, advocate, Bouchard, avocat tous de Coaticook, district all of Coaticook, judicial district of St.Francis, judiciaire de Saint-François, pour les objets for the following purposes: suivants: Exploiter en particulier un ou des brevets de To utilize in particular one or more patents metallisation de tous corps non-conducteurs, sous for the metallization of any non-conducting le nom de \"Metalco Limitée\" \u2014 \"Metalco Lima- bodies, under the name of \"Metalco Limitée\" \u2014 ted\", Metalco Limited\", Le montant du capital-actions de la compagnie The amount of capital stock of the company est de 1,000 actions ordinaires sans valeur au is 1,000 common shares without par or nominal pair ou nominale, et de 2,000 actions privilégiées value, and 2,000 preferred shares of $100 each, de $100 chacune, et le montant avec lequel la and the amount with which the company will la compagnie commencera ses opérations est de commence its operations is $25,000.$25,000.Le siège social de la compagnie sera à Coati- The head office of the company will be at Coa- cook, district judiciaire de Saint-François.ticook, judicial district of Saint-Francis. 2126 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 août 1951, Tome 88, N° 81 Daté du bureau du Procureur général le quatorze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.Noral Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du premier juin 1951, constituant en corporation : Florence Mary Trinnell Kay, ménagère, épouse séparée de biens de Norval Kay, et dûment autorisée par lui pour les présentes, Abe Goldberg, autorité en relations publiques, et Dame Mina Kotick Goldberg, ménagère, épouse séparée de biens de Abe Goldberg, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands-commerçants d'aucunes et toutes sortes de bois, laine et rebuts soit bruts ou manufacturés, sous le nom de \"Noral Trading Corporation\", avec un capital de $35,000 divisé en 150 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.-E.CANTIN.Nouvelles Modes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S,R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier juin 1951, constituant en corporation: Sam Adel, marchand, Emmanuel Cookc, avocat, et Lucy V.Clarke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce en détail de toutes sortes de vêtements confectionnés pour dames, lingerie fourrures et tous autre articles s'y rattachant, sous le nom de \"Nouvelles Modes Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3545 est, rue Ontario, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant,, 30622 C.-E.CANTIN.Olivier Holding Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du six juin 1951, constituant en corporation: Claude Ducharme, avocat, de Richelieu, district judiciaire de Ste-Hyacinthe, Guy Desjardins, avocat, et Jean Olivié, alias Olivier, industriel, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie d'administration et de portefeuille, sous le nom de Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30022 Acting Deputy Attorney General.Noral Trading Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the first day of June, 1951, incorporating: Florence Mary Trinnell Kay, housewife, wife separate as to property of Norval Kay, and duly authorized by him for these presents, Abe God berg, public relations authority and Dame Mina Kotick Goldberg, house wife, wife separate as to property of Abe Goldberg, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of trading merchants of any and all kinds of wood, wool, and waste materials whether raw or manufactured, under name of \"Noral Trading Corporation\", with a capital stock of $35,000 divided into 150 preferred shares of S100.each, and 200 common shares of S100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30G22-o Acting Deputy Attorney General.Nouvelles Modes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the first day of June, 1951, incorporating: Sam Adel, merchant, Emmanuel Cooke, advocate, and Lucy V.Clarke, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business, retail of all kinds of ladies ready to wear clothing, lingerie, furs, and in all other things appertaining to wearing apparel, under the name of \"Nouvelles Modes Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at 3545 Ontario St.E.Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Olivier Holding Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-rissct, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixth day of June, 1951, incorporating: Claude Ducharme, advocate, of Richelieu, Judicial District of St-Hyacinthe, Guy Desjardins, advocate, and Jean Olivié, alias Olivier industrial, both of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of an administration and holding company, under the name of \"Olivier QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August /,th, 1951, Vol 88, No.31 2127 \"Olivier Holding Inc.\" avec un capital de 8200,000 divisé en 19,850 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune, et 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de là compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.-E.CANTIN.Paul Heller Fuel Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze juin 1951, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, advocats, et Freda Pomerance, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de charbon et de coke, vendeurs de toutes sortes de combustible, sous le nom de \"Paul Heller Fuel Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le-quinze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.-E.CANTIN.Princcvillc Pulpe Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize juin 1951, constituant en corporation: Oscar chard, menuisier, Arsène Sylvain, commerçant, et Georges-Albert Héchard.gérant, tous de P.in-ceville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer en général le commerce de bois, sous le nom de \"Princcvillc Pulpe Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 800 actions de S50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Princcvillc, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le treize juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.Rodgcrs-Short Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi de la province de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze juin 1951, constituant en corporation: Charles Wolfson, avocat, Alva P.Boyd, sténographe, et William Henry Rodgers, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeuble soils le nom de \"Rodgers Short Inc.\" avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Holding Inc.\", with a capital stock of $200,000.divided into 19,850 preferred shares having a par value of 810.each, and 1,500 common shares having a par value of SI.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of June, 1951.« C.-E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Paul Heller Fuel Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of June, 1951, incorporating: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, advocates, and Freda Pome-ranee, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of coal and coke merchants, dealers in all kinds of fuel, under the name of \"Paul Heller Fuel Ltd.\", with a capital stock of 840,000.divided into 100 common shares of the par value of 8100.each and 300 preferred shares of the par value of 8100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Princeville Pulpe Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of June, 1951, incorporating: Oscar Béchard, joiner, Arsène Sylvain, trader, and Georges Albert Béchard, manager, all of Princeville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on the lumber business in general, under tlu name of \"Princeville Pulpe Ltée\", with a capital stock of 840,010 divided into 800 shares of $50 each.The head office of the company will be at Princeville, judicial district of Arthakasba.Dated at lite office of the Attorney General, this thirteenth day of June, 1951.C.-E, CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Rodgers-Short Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, lettere patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1951, incorporating: Charles Wolfson, advocate, Alva P.Boyd, stenographer, and William Henry Rodgers, accountant, all cf the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Rodgers-Short Inc.\", with a capital stock of 840,000.divided into 400 shares of 8100.each. 2128 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 acût 1951, Tome 83, N° SI Le siège social de la compagnie sera à Westmount, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.-E, CANTIN.Simard Express Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux juin 1951, constituant en corporation: Fortunat Simard, camionneur, Jean Simard, camionneur, tous deux d'Hébertville, district judi-aire de Roberval, et Lucienne Morin, sténographe, de Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de transport, sous le nom de \"Simard Express Limitée\", avec un capital de $75,000 diviséen 750actions de$100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hébert-ville, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.St.Denis Construction Ltée St.Denis Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-huit mai 1951, constituant en corporation: Roger Hamelin, entrepreneur, Joseph-Edmond Milot comptable, et Jacques Décarie, entrepreneur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme constructeur ou entrepreneur, sous le nom de \"St.Denis construction Ltée\" \u2014 \"St.Denis Construction Ltd.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit mai 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o » - C.-E.CANTIN.Steel Structure & Services Ltd.Avis est donné qu'en vertu delà première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du six juin 1951, constituant en corporation: Emé.Lacroix, C.R., avocat, de Ville Mont-Royal, Lucien Thouin, advocat, et Paula Boisvert, sténographe, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme contracteur, constructeur général de tous immeubles quelconques, sous le nom de \"Steel Structure & Services Ltd.\", avec un capital de $100,000 divisé en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.The head office of the Company will be at West-mount, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30G22-o Acting Deputy Attorney General.Simard Express Limitée Notice is hereby given that under Tart I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of June, 1951, incorporating: Fortunat Simard, carrier, Jean Simard, carrier, both of Hébertville, judicial district of Roberval, and Lucien Morin, stenographer, of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To engage in the transportation business, under the name of \"Simard Express Limitée\", with a capital stock of $75,000 divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Hébertville, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this second day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.St.Denis Construction Ltée St.Denis Construction Ltd.\u2022 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eight day of May, 1951, incorporating: Roger Hamelin, contractor, Joseph Edmond Milot, accountant, and Jacques Décarie, contractor, all of the- city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as builder or contractor, under the name of \"St.Denis Construction Ltée\" \u2014 \"St.Denis Construction Ltd.\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Ville Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eight day May, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Steel Structure & Services Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixth day of June, 1951, incorporating: Emé.Lacroix, K.C., advocate, of the Town of Mount Royal, Lucien Thouin advocate, and Paula Boisvert, stenographer, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for-the following purposes: To act as contractor and general builder for immovables of all kinds, under the name of \"Steel Structure & Services Ltd.\", with a capital stock of $100,000 divided into 800 preferred shares of a par value of 8100 each and 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 4th, 1951, Vol 88, No.81 2129 Daté du bureau du Procureur général le six juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.Xavier Gauthier Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt juin 1951, constituant en corporation: Raymond Gauthier, Roger Gauthier et Rosaire Gauthier, garagistes, tous de Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de garage, sous le nom de \"Xavier Gauthier Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le vingt juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622-o C.-E.CANTIN.Coronet Télévision Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt et un juin 1951, constituant en corporation: John Bumbray, Conseil en Loi du Roi, Lovell Caverhill Carroll, Conseil en Loi du Roi, tous deux de la ville de Mont-Royal, Jehan Perdriau, Jean-Paul Cardinal, Bernard Lcbcl, avocats, Thérèse Boissy et Thérèse Tétu secrétaires, tous cinq de la cité de Montréal, et tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de toutes sortes d'appareils de télévision et radio, accessoires électriques, articles de ménage, matériaux de construction et ameublement, sous le nom de \"Coronet Television Corporation\", avec un capital de $750,000 divisé en 750,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30622 C.-E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Xavier Gauthier Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of June, 1951, incorporating: Raymond Gauthier, Roger Gauthier and Rosaire Gauthier, garage-keepers, all of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the garage business, under the name of \"Xavier Gauthier Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Cated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622 Acting Deputy Attorney General.Coronet Télévision Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the pro-* vince of Quebec, represented by Mr.Alfred Mo-risset, in conformity with section 2, chapter 276, 1941, bearing date the twenty-first day of June, 1951, incorporating: John Bumbray, Kings Counsel, Lovell Caverhill Carroll, King's Counsel, both of the Town of Mont-Royal, Jehan Perdriau, Jean-Paul Cardinal, Bernard Lebel, advocates, Thérèse Boissy and Thérèse Tétu, secrétaires, all five of the City of Montreal, and all in the judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business of manufacturers and dealers in and of all kinds of television, radio, electrical, household building and housing products, under the name of \"Coronet Television Corporation\", with a capital stock of $750,000.divided into 750,000 shares of $1 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30622-o Acting Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Cash Register Importers Ltd.Cash Register Importers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies Act, supplementary let- accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- ters patent, bearing date the 2nd day of June, vince de Québec, des lettres patentes supplémen- 1951, were issued by the Lieutenant-Governor taires en date du deux juin 1951 à la compagnie of the Province of Quebec, to the company \"Cash Register Importers Ltd.\", étendant ses \"Cash Register Importers Ltd,\", extending its pouvoirs.powers.Daté du bureau ¦ du Procureur général, le 2 Dated at the office of the Attorney General, juin 1951.the 2nd day of June, 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, C.-E.CANTIN, 30623 C.-E.CANTIN.30623-o Acting Deputy Attorney General. 2130 GAZETTE OFFICIELLE DE QIÎÉBEC, Québec, 4 août 1.051, Tome S3, N° SI Champlain Milk Products Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires enîlatc du S juin 1951, à la compagnie \"Champlain Milk Products Company Limited\", ratifiant son règlement spécial \"A\" augmentant son capital autorisé de S45,000 à $295,000 par la création de 250,000 actions privilégiées additionnelles de $1 chacune, comprenant les droits, restriction» et privilèges énoncés au dit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 8 juin 1951., L'Assistant-procureur général suppléant, 30623 C.-E.CANTIN.Fred F.ESler Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du six juin 1951, à la compagnie \"Fred F.Esler, Limited\", ratifiant son règlement \"AA\", augmentant son capital île S55.000 à $200,000 par la création de a) 5,000 actions ordinaires additionnelles de $1 chacune; b) 800 actions privilégiées additionnelles de 850 chacune, pour être classées pan' passu en tous respects avec les actions privilégiées déjà existentes de la compagnie crée par lettres patentes en date du 7 décembre 1931; c) 2,000 nouvelles \"actions privilégiées spéciales\" de 850 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 6 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623 C.-E.CANTIN.Grand Slipper Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, de la dite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres supplémentaires en date du 14 juin 1951 à la compagnie \"Grand Slipper Inc.\", ratifiant un règlement, augmentant le capital de ladite compagnie de $40,000 à $140,000 par la création de 200 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune et de 800 actions privilégiées additionnelles de S100 chacune, comprenant les droits et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 14 juin 1951.\u2022 L'Assistant-procureur général suppléant, 30623 C.-E.CANTIN.Knight Armature Manufacturing Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 3 juillet 1951, à la compagnie \"Knight Armature Services Incorporée\", constituée en corporation par lettres patentes du 11 octobre 1950, changeant son nom en celui de \"Knight Armature Manufacturing Incorporée\".Champlain Milk Products Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the Sth day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Champlain Milk Products Company Limited\", ratifying its Special By-law \"A\" increasing its authorized capital from 845,000 to 8295,000 by the creation of 250,000 additional preferred shares of 81 each, comprising the rights, restrictions and privileges set forth in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 8th day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623-o Acting Deputy Attorney General.Fred F.ESlcr Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 6th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Fred F.Esler, Limited\", ratifying its By-law \"AA\" in-rcasing its capital stock from 855,000 to 8200,000 by the creation of a) 5,000 additional common shares of 81 each; b) 800 additional preferred shares of S50 each to rank pari passu in all respects eith the already existing preferred shares of the company created by the letters patent of December 7, 1931; c) 2,000 new \"special preferred shares of\" 850 each, subjets to the rights and restrictions mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 6th day of June 1951 .C.-E.CANTIN, 30G23-o Acting Deputy Attorney General.Grand Slipper Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Grand Slipper Inc.\", ratifying a bylaw increasing the capital stock of such company from 840,000 to 8140,000 by the creation of 200 additional common shares of 8100 each and of 800 additional preferred shares of $100 each, comprising the rights and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 14th day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623-o Acting Deputy Attorney General.i Knight Armature Manufacturing Incorporée Notice si hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the third day of July 1951, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Knight Armature Service Incorporée\", incorpored by letters patent dated the eleventh day of October, 1950.changing its name into that of \"Knight Armature Manufacturing Incorporée\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August J,th, 1951, Vol 83, No.31 2131 Daté du bureau du Procureur général, le 3 juillet 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30G23-o C.-E.CANTIN.Les Magasins Maisonneuvc Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 juin 1951.à la compagnie \"Les Bouchers-Epiciers de Maison-neuve Limitée \u2014 The Maisonneuvc Butchers-Grocers Limited\", constituée en corporation par lettres patentes du 1er mai 19-16, changeant son nom en celui de \"Les Magasins Maisonneuvc Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le 6 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623-o C.-E.CANTIN.Musarra Fabrics Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 juin 1951, changeant le nom de la compagnie \"Steinberg Fabrics Inc.\", incorporée par lettres patentes en date «lu 2 avril 1951, en celui de \"Musarra Fabrics Ltd\".Daté du bureau du Procureur général, le 18 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623 C.-E.CANTIN.Mysto Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 juin 1951, à la compagnie \"Mysto Inc.\", ratifiant son règlement \"E\" augmentant son capital-actions par la création de 5,000 actions privilégiées nouvelles de 810 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement, et fixant à $20,000 le montant minimum avec lequel la compagnie continuera ses* opérations.Daté du bureau du Procureur général, le 6 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623-o C.-E.CANTLN.Sceley Systems (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 20 juin 1951, à la compagnie \"Seeley Systems (Quebec) Limited\", ratifiait son règlement No 61: 1° subdivisant 300 actions ordinaires de $100 chacune en 3000 actions ordinaires de $10 chacune; 2° convertissant les dites 3,000 actions ordinaires de 810 chacune en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune, comprenant les droits et restrictions mentionnés audit règlement.Dated at the office of the Attorney General, this third day of July, 1951.C.-E.CANTIN, 30623 Acting Deputy Attorney General.Les Magasins Maisonneuvc Limitée Notice is hereby givent that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the sixth day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941,'chapter 276, to the company \"Les Bouchers-Epiciers de Maison-neuve Limitée \u2014 The Maisonneuvc Butchers-Grocers Limited\", incorporating by letters patent dated the first day of May, 1946, changing its name into \"Les Magasins Maisonncuve Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623 Acting Deputy Attorney General.Musarra Fabrics Ltd.Notice si hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, changing the name of the company \"Steinberg Fabrics Inc.\", incorporated by the letters patent dated April 2nd, 1951, to that of \"Musarra Fabrics Ltd.\", Dated at the office of the Attorney General, the 18th day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623-o Acting Deputy Attorney General.Mysto Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the sixth day of June, 1951, were issued by t'.'e Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Mysto Inc.\", ratifying its By-Law \"E\" increasing its capital stock by the creation of 5,000 new preferred shares of $1Q each, subjet to the rights and restrictions mentioned in the said by-law, and fixing at $20,000 the minimum amount with which the company will continue its operations.Dated at he office of the Attorney General, this sixth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623 Acting Deputy Attorney General.Seeley Systems (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Seeley Systems (Quebec) Limited\", ratifying its By-Law No.61: 1° subdividing 300 common shares of $100 each into 3,000 common shares of $10 each; 2° converting the said 3,000 common shares of $10 each into 3,000 preferred shares of $10 each, comprising the rights and restrictions mentioned in the said by-law. 2132 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 août 1951, Tome 83, N° 31 Daté du bureau du Procureur général, le 20.Dated at the office of the Attorney General, juin 1951.this 20th day of June, 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, C.-E.CANTIN, 30623 C.-E.CANTIN.30623-o Acting Deputy Attorney General.Sylvia Fair Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset conformément avec l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 20 juin 1951, à la compagnie\"Neckwear Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes et lettres pates supplémentaires en date respectivement le 3 juin 1946 et le 23 décembre 1948, changeant son nom en celui de \"Sylvia Fair Inc.\", Daté du bureau du Procureur général, le 20 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623 C.-E.CANTIN.The Crystal Palace Theatre Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 15 juin 1951, à la compagnie \"The Crystal Palace Theatre Limited\", ratifiant son règlement no 3 augmentant son capital de $20,000 à $50,000 par la création de 300 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau d Procureur général, le 15 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623-o C.-E.CANTIN.Thom8on-Gingras Lumber Co.Limited Avis estdonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 juin 1951, à la compagnie \"Thomson-Gingras Lumber Co.Limited\", ratifiant son règlement no 16 partant son capital-actions de $10,000 à $260,000.par la création de 2500 actions privilégiées nouvelles de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 19 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30623-o .C.-E.CANTIN.Union Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 18 juin 1951, à la compagnie \"Union Products Inc.\", ratifiant son règlement No 28 augmentant son capital de $25,000 à $85,000 par la création de 600 nouvelles actions privilégiées de $100 chacune, comprenant Sylvia Fair Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Neckwear Incorporated\", incorporated by letters patent and supplementary letters patent dated, respectively, June 3,1946 and December 23, 1948, changing its name to that of \"Sy-via Fair Inc.\".Dated at the office ot the Attorney General, this 20th day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623-o Acting Deputy Attorney General.The Crystal Palace Theatre Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the fifteetnh day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"The Crystal Palace Theatre Limited\", ratifying its By-law No.3, increasing its capital from $20,000 to $50,000 by the creation of 300 pitferred shares of $100 each, subject to the rights restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623 Acting Deputy Attorney General.Thom8on-Gingras Lumber Co.Limited Notice is hereby given that Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the nineteenth day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Thomson-Gingras Lumber Co.Limited\", ratifying its By-Law No.16 increasing its capital stock from $10,000 to $260,000 by the creation of 2,5000 new preferred shares of $100 each, subjet to the rights and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1951.C.-E.CANTIN, 30623 Acting Deputy Attorney General.Union Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Union Products Inc.\", ratifying its By-Law No 28 increasing its capital stock from $25,000 to $85,000 by the creation of 600 new preferrd shares of $100 each, comprising the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 4th, 1951, Vol S3, No.31 2133 les droits et restrictions mentionnés au susdit rights and restrictions mentioned in the aforesaid règlement.by-law.Daté du bureau du Procureur général, le 18 Dated at the office of the Attorney General, juin 1951.this 18th day of June, 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, C.-E.CANTIN, 30623 C.-E.CANTIN.30623-o Acting Deputy Attorney General.Industrial Finance Corporation Limited Industrial Finance Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres supplémentaires en date du 28 juin 1951, à la compagnie \"Industrial Finance Corporation Limited\", ratifiant son règlement N° 1, subdivisant 2895 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, en 57,900 actions, et convertissant ces 57,900 actions en 57,900 actions privilégiées de $5 chacune, énumé-rant les privilèges attachés à telles actions privilégiées et fixant à $39,475 le montant avec lequel la compagnie exercera dorénavant ses opérations.Daté du bureau du Procureur général, ce 28 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30647 C.E.CANTIN.Levis Textile Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur df la province de Québec,.représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q., 1941, chap.276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 29 juin 1951, à la compagnie \"Levis Textile Limited\", ratifiant son règlement no 5 augmentant son capital autorisé de $40,000 à $70,000 par la création de 100 actions communes additionnelles de $i00 chacune et de 200 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, comportant les mêmes droits, restrictions et privilèges que ceux attachés aux actions privilégiées antérieurement autorisées.Daté du bureau du Procureur général, le 29 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30647-o C.E.CANTIN.North End Tile Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouvQrnaur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941, chap.276, des lettres patentes supplémentaires en date du 27 juin 1951, à la compagnie \"North End Tile Co.Limited\", ratifiant son règlement spécial \"A\", augmentant son capital de $35,000 à $85,000 par la création de 5,000 actions privilégiées de $10 chacune, comprenant les droits, restrictions et privilèges mentionnés au susdit règlement.Daté au bureau du Procureur général, ce 27 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30647 C.E.CANTIN.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Industrial Finance Corporation Limited\", ratifying its Bylaw No.1 subdividing 2895 common shares without nominal or par value into 57,900 shares, and converting these 57,900 shares into 57,900 preferred shares of $5 each, enumerating the privileges attaching to such preferred shares, and fixing at $39,475 the amount with which the company will henceforth carry on its operations.Dated at the office of the Attorney General, this 28th day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30647-o Acting Deputy Attorney General.Levis Textile Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-ninth day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chap.276, to the company \"Levis Textile Limited\", ratifying its By-law No.5 increasing its authorized capital from $40,000 to $70,000 by the creation of 100 additional common shares of $100 each and 200 additional preferred shares of $100 each, subject to the same rights, restrictions and privileges as those attaching to the preferred shares heretofore authorized.Dat'd at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30647 Acting Deputy Attorney General.North End Tile Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of th*> Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chap.276, to the company \"North End Tile Co.Limited\", ratifying its Spécial By-law \"A\" increasing its capital from $35,000 to $85,000 by the creation of 5,000 preferred shares of $10 each, comprising the rights, restrictions and privileges mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 27th day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30647-o Acting Deputy Attorney General.Spitfire Fasteners Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chap.276, des lettres patentes sup- Spitfire Fasteners Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said 2134 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 août 1951, Tome 88, N° 81 plémcntaircs en date du 29 juin 1951, à la compagnie \"Spitfire Fasteners Inc.\", ratifiant son règlement N° 24, augmentant son capital de $40,000 à $70,000 par la création de 3,000 actions privilé-> giées additionnelles de $10 chacune, comprenant les mêmes droits et restrictions que ceux attachés aux actions privilégiées créées par les lettres patentes.Daté du bureau du Procureur général, le 29 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30G47 C.E.CANTIN.St.George Woollen Mills Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dè la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chap.276, des lettres supplémentaires en date du 20 juin 1951, à la compagnie \"St.George Woollen Mills Limited\", ratifiant son règlement N° 4, augmentant son capital de $299,000 à 8799,000 par la création de 5,000 actions privilégiées de 8100 chacune, comprenant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans un tel règlement.Daté au bureau du Procureur général, ce 20 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30647 C.E.CANTIN.Act, R.S.Q.1941, chap.276, to the company \"Spitfire Fasteners Inc.\", ratifying its By-law No.24 increasing its capital stock from $40,000 to $70,000 by the creation of 3,000 additional preferred shares of $10 each, comprising the same rights and restrictions as those attaching to the preferred shares created by the letters patent.Dated at the office of the Attorney General, this 29th day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30647-o Acting Deputy Attorney General.St.George Woollen Mills Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, S.R.Q.1941, chap.276, to the company \"St.George Woollen Mills Limited\", ratifying its By-law No.4 increasing its capital stock from $299,000 to $799,000 by the creation of 5,000 preferred shares of $100 each, comprising the rights, restrictions and privileges set out in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 20th day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30647-o Acting Deputy Attorney General.Superior Brand Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chap.276, des lettres patentes supplémentaires en date du 26 juin 1951, à la compagnie \"Superior Brand Limited\", ratifiant son règlement \"D\", augmentant son capital de $20,000 à $100,000 par la création de 8,000 nouvelles actions privilégiées de $100 chacune, comprenant les droits et restrictions mentionnés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 26 juin 1951.L'Assistant-procureur général suppléant, 30647 C.E.CANTIN.Superior Brand Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of June, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Superior Brand Limited\", ratifying its By-law \"D\" increasing its capital stock from $20,000 to $100,000, by the creation of 8,000 new preferred shares of $100 each, comprising the rights and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 26th day of June, 1951.C.E.CANTIN, 30647-o Acting Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens Canada, Province de Québec, district de Ri-mouski, Cour Supérieure, N° 13326.Dame Marie-Louise Charest, épouse commune en bien de Léon Couturier, cultivateur et commerçant de charbon, de la paroisse de St-Benoit Joseph Labre d'Amqui, Vulgo Amqui, district de Rimouski, demanderesse, vs le dit Léon Couturier, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause, le 21 juillet 1951.Rimouski, 25 juillet 1951.Le Procureur de la demanderesse, 30624-o R.E.ASSELIN, avocat, Rimouski.Prenez avis que Dame Julia Loiselle, épouse commune en biens d'Edouard Berge vin, des cité et district de Montréal, a formé contre son mari une demande en séparation de biens dans une Actions for separation as to property Canada, Province of Quebec, district of Rimouski, Superior Court, No.13326.Dame Marie-Louise Charest, wife common as to property of Léon Couturier, farmer and coal-merchant, of the parish of St-Benoit Joseph Labre d'Amqui, vulgo Amqui (district of Rimouski, plaintiff, vs the said Léon Couturier, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this case, on the 21th July, 1951.Rimouski, July 25, 1951.R.E.ASSELIN, advocate, Rimouski, 30624-o Attorney for the plaintiff.Notice is given that Dame Julia Loiselle, wife common as to property of Edouard Bergevin, of the City and district of Montreal, has instituted an action against her husband, for sepa- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August /,th, 1951, Vol.83, No.31 2135 cause N° 302805, Cour Supérieure, Montréal.Montréal, le 30 juillet 1951.Les Procureurs de la demanderesse, 30643-o Raymond, Laxglois & Bissonxet.ration as to property, case No.302805, Superior Court, Montreal.Montreal, July 30th 1951.Raymond, Laxgixjis & Bissonnet, 30643-o Attorneys for the plaintiff.Arrêtes en Conseil Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEn, CHAMBRE DU CONSEIL ÎXÉJUTIF ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 797 Number 797 Québec 25 juillet 1951.Quebec, July 25, 1951.Présent: Le Lieutenant-gouverneur-en-Conseil Present: The Lieutenant-Governor in Council Section \"E\" Part \"E\" Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments to the decree relating à l'industrie de la construction dans la région to the construction industry in the district of de Sorel.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts Refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendments), les parlies contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans la région de Sorel, rendue obligatoire par le décret numéro 1764 du 2 septembre 1938, amendé par les arrêtés en conseil numéros 2067 du 7 octobre 1938, 4063 du 14 novembre 1940, 146 du 24 janvier 1941, 1249 et 1897 des 27 mai et 30 juillet 1942, 51 et 148 des 13 et 22 janvier 1943, 3169 du 16 août 1944, 3431 et 4154 des 28 août et 10 octobre 1946, 298-A, 1729-B et 1882-A des 13 février, 23 octobre et 12 novembre 1947, 623-C et 1221-A des 15 juin et 2 novembre 1949, 850-E, 973-A et 1094-D des 19 juillet, 30 août et 4 octobre 1950, ont présenté au Ministère du Travail une requête à l'effet de mo lifier ledit décret, dans sa teneur modifiée; Attendu qus ladi'e requête a été publiée dans la Gdzette officielle te Québec, édition du 23 juin 1951 ; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le dit décret, numéro 1764, soit modifié comme suit: 1° La cédule des taux minima de salaires apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article HI est remplacée par la suivante: Métiers : Briqueteur, plâtrier, maçon et finisseur de ciment.Charpentier-menuisier, y compris poseur de paravents, bois ou métal, châssis, fenêtre, divisions en acier.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.