Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 15 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1951-12-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 83, N° 50 3353 Vol.83, No.50 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (l4Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubushed by the provincial govern ment) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 15 décembre 1951 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, December 15th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if.any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter.0270 3351 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1961, Tome 83, N° 60 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le'droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u2014 1-52 Lettres patentes Allan Singer Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le licutenat-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRi-chelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-six octobre 1951, constituant en corporation Wyndham Alfred Strover, avocat, Kenneth Charles Mackay.avocat, tous deux delacité de Montréal et Joseph Henry Porteous, avocat, de la ville de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de livres, papeterie, accessoires et fournitures scolaires, articles de sport et marchandises de fantaisie et agir comme éditeurs, imprimeurs, lithographes et relieurs, sous le nom receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week\"be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the-first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.29088 \u20141-52 Letters Patent Allan Singer Limited Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of October, 1951, incorporating: Wyndham Alfred Strover, advocate, Kenneth Charles Mackay, advocate, of the City of Montreal, and Joseph Henry Porteous, advocate, of the City Town of Hampstead, all in the Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers in books, stationery, school supplies and equipment, sporting goods and fancy books, and to act as publishers, printers, lithographers and bookbindres, under the name of \"Allan Singer QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol 83, No.50 3355 de \"Allan Singer Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1030 rue Bleury, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1951 L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Limited\", with a capital stock of S40.000 divided into 400 shares of S100 each.The head office of the Company will be at 1030 Bleury Street, Montreal, judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth day of \"October, 1951.L.DÉSILETS 31627-0 Deputy Attorney General.Barraute Lumber Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du deux novembre 1951, constituant en corporation: Harry Hlank,avocat,June Kirlin, sténographe, tous deux de la cité de Montréal et Joyce Hogg, sténographe, de Maisonneuvc, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Effectuer des opérations forestières et faire le commerce de bois de construction, sous le nom de \"Barraute Lumber Co Ltd,\",avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lau-rent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1951.L'Assistant -procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Berger de Paris Lté\"c Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf octobre 1951, constituant en corporation: Edmond-Jacques Courtois, Edward Her-rick Knatchbull-Hugessen, avocats, de Montréal, et Ross Trenholme Clarkson, avocat, de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'objet, article ou marchandise en cuir, sous le nom de \"Berger de Paris Ltée\", avec un capital de §10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1544, rue Crescent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Canada Door Installers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du deux octobre 1951, constitutant en corporation: Y von Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau et Rita Dufresne, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction, meubles et articles en bois, sous le nom de \"Canada Door Installers Ltd.\", avec un capital de 815,000 divisé en 150 actions communes de S10 chacune et en 135 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dé Montréal.Barraute Lumber Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of November, 1951, incorporating: Harry Blank, advocate, June Kirlin, stenographer, both of the city of Montreal, and Joyce Hogg, stenographer, of Maisonneuve, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry, on the business of lumbering and the lumber trade, under the name of \"Barraute Lumber Co.Ltd.\", with a capital stock of 840,000 divided into 400'shares of S100 each.The head office of the company will be at St.Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Berger de Paris Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of October, 1951, incorporating: Edmond Jacques Courtois, Edward Herrick Knatchbull-Huggessen, advocates, of Montréal, and Ross Trenholme Clarkson, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise made of leather, under the name of \"Berger de Paris Ltée\", with a capital stock of 810,000 divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1544 Crescent street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney' General, this twenty-ninth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Canada Door Installers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the second day of October, 1951, incorporating: Y von Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau and Rita Dufresne, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in building materials, furniture and wooden articles, under the name of \"Canada Door Installers Ltd.\", with a capital stock of $15,000, divided into 150 common shares of $10 each, and 135 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 335G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 88, N° 50 Daté du bureau du Procureur général le deux octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Charlotte Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux novembre 1951, constituant en corporation: Nathaniel Leonard Rappaport, Hyman Eric Fei-gelson, avocats et James Topping, surintendant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce d'une certaine propriété, sous le nom de \"Charlotte Limited\", avec un capital de 899,000 divisé en 9,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune et 900 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Thetford Mines, district judiciaire d'Arthahaska.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Charlotte Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of November, 1951, incorporating: Nathaniel Leonard Rappaport, Ilyman Eric Feigelson, advocates, and James Topping, superintendent, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with a certain property, under the name of \"Charlotte Limited\", with a capital stock of 899,000 divided into 9,000 preferred shares of a par value of 810 each, and 900 common shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Thetford Mines, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Club de Hockey Laehine Rapides Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf octobre 1951, constituant en corporation sans capital-actions, Jacques Viau, avocat, Jean Barbarie, et Marcel Champagne, commis de bureau, tous trois de Lachine, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir les exercices de sport, sous le nom de \"Club de Hockey Lachine Rapides\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 825,000.Le siège social de la corporation sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Desroches & Frère Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des letrres patentes, en date du vingt-neuf octobre 1951, constituant en corporation: Donat DesRoches, entrepreneurs-plombier.Jean-Paul G.Grenier, entrepreneur, et Robert Grenier, notaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le métier d'cntrepreneur-plombier, d'entreprencur-élcctricien, sous le nom de \"Desroches & Frère Inc.\", avec un capital de S45.-000 divisé en 400 actions ordinaires de 825 chacune, et en 350 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 .L.DÉSILETS.Club de Hockey Lachine Rapides Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of October, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Jacques Viau, advocate, Jean Barbarie, and Marcel Champagne,, office clerks, all three of Lachine, judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote the exercise of sports, under the name of \"Club de Hockey Lachine Rapides\".The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is 825,000.The head office of the corporation will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of October, 1951.L.DÉSILETS.31627 Deputy Attorney General.Desroches & Frère Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of October, 1951, incorporating: Donat «-Desroches, plumbing contractor, Jean-Paul G.Grenier, contractor, and Robert Grenier, notary all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the trade of plumbing contractor and electrical contractor, under the name of \"Desroches & Frère Inc.\", with a capital stock of 845,000 divided into 400 common shares of 825 each, and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of October, 1951.L.DÉSILETS,' 31627 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.88, No.50 3357 Editions J.Dupuis, Fils & Cie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes en date du vingt-neuf octobre 1951, constituant en corporation: Armand-H.Viau, Jacques-H.Viau, comptables, de Verdun, et Laurel Mauffette, comptable, de Lakeside, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeur, libraire, éditeur, sous le nom de \"Editions J.Dupuis, Fils & Cie Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au jJtiir de $100 chacune, et en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de 825 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Fourrures Belmont Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six novembre 1951, constituant en corporation: Roland Bélanger, pelletier, de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, Philip Markus et Edward Markus.pelletiers, tous deux de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de fourrures, vêtements et marchandises sèches, sous le nom de \"Fourrures Belmont Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et 10Q actions privilégiés de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 - L.DÉSILETS.Editions J.Dupuis, Fils & Cie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of October, 1951, incorporating: Armand H.Viau, Jacques H.Viau, accountants, of Verdun, and Laurel Mauffette, accountant, of Lakeside all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as printer stationer, editor, under the name of \"Editions J.Dupuis, Fils & Cie Inc.\", with a capital stock of 840,0000, divi-aivided into 300 preferred shares of a par value of 8100 each and 400 common shares of a par value of S25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Fourrures Belmont Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of November, 1951, incorporating: Roland Bélanger, furrier, of Sherbrooke, Judicial District of St.Francis, Philip Markus' arid Edward Markus, furriers, both of the City of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and dealer in furs, wearing appajel and dry goods, under the name of \"Fourrures Belmont Inc.\", with a capital stock of 840,000.divided into 300 common shares of 8100.each and 100 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Frank A.Patrick Limited Avis est donné qu'en vertu dp la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente octobre 1951, constituant en corporation: Samuel E.Schwisberg, conseil en loi du Roi, Cyril E.Schwisberg, avocats, de la cité d'Outremont et Sonya Schneyer, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de travaux en bois et toutes sortes de produits fabriqués de cuir, caoutchouc, métal, papier, nylorî, plastique, fourrure, textiles, verre et leurs sous-produits, sous le nom de \"Frank A.Patrick Limited\", avec un capital de 860,000 divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS, Frank A.Patrick Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of October, 1951, incorporating: Samuel E.Schwisberg, King's Counsel, Cyril E.Schwisberg, advocates, of the City of Outrcmont, and Sonya Schneyer, secretary, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in woodwork and in all kinds of products made of leather, rubber, metal, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products, under the name of \"Frank A.Patrick Limited\", with a capital stock of 860,000 stock divided into 300 common shares of 8100.each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General. 3358 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 83, N° 50 Garage National de St-Georges Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq octobre 1951, constituant en corporation: Maurice Lessard, garagiste, Gérard Lessard, agent vendeur, et Emile Poirier, mécanicien, tous de Saint-Georges, district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles et leurs accessoires et exploiter des garages, sous le nom de \"Garage National de St-Georgcs Incorporée\", avec un capiral de 8100,000 divisé en 1.000 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Georgcs, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Hôpital Voghcl Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six octobre 1951, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, c.r., Manuel Shacter, avocats et Anne Ross, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un hôpital général, sous le nom de \"Hôpital Voghel Inc.\", avec un capital de $250,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 2,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.J.-A.Angel & Son Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux novembre 1951, constituant en corporation: George Beverly Puddicombe, avocat et Conseil en Loi du Roi, William Randolph Noble, avocat, tous deux de la cité de Westmount, et John William Long, avocat et Conseil en Loi du Roi, de la cité d'Outrcmont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce des produits de la mer, de la terre et de la forêt, marchandises sèches, ferronnerie, machineries, moteurs, instruments de toutes sortes, sous le nom de \"J.-A.Angel & Son Ltd.\", avec un capital de 820,000 divisé en 200 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 .L.DÉSILETS.Jack Migneault Limitée _ Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Garage National de St-Georges Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of October, 1951.incorporating: Maurice Lessard, garage-keeper, Gérard Lessard, sales agent, and Emile Poirier, mechanic, all of Saint-Georges, judicial district of Beaucc, for the following purposes: To deal in automobiles and the accessories thereof, and operate garages, under the name of \"Garage National de St-Georgcs Incorporée\", with a capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at the town of Georges, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Hôpital Voghel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of October, 1951, incorporating: Louis H.Rohrlick, K.C.\u201e Manuel Shacter, advocates, and Anne Ross, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate a general hospital, under the name of \"Hôpital Voghel Inc.\", with a capital stock of 8250,000, divided into 100 common shares of the par value of 8100 each, and 2,400 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentv-sixth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.J.-A.Angel & Son Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebecf bearing date the second day of November, 1951, incorporating: George Beverly Puddicombe, advocate and King's Counsel, William Randolph Noble, advocate, both of the city of Westmount, and John William Long, advocate and king's Counsel, of the city of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in products of sea, land and forest, dry goods, hardware, machineries, motors, implements of all kinds, under the name of \"J.-A.Angel & Son Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200\" shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Jack Migneault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.S3, No.60 3359 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Laltiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq octobre 1951, constituant en corporation: Monique Couture, secrétaire, Lionel Lefcb-vre, comptable, et Cécile Lahaie, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles, moteurs et leurs accessoires, et exploiter des garages, sous le nom de \"Jack Mignault Limitée\", avec un capital de 520,000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Joliette Scrap Iron & Metal Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre octobre 1951, constituant en corporation: Edouard Péloquin.commerçant, Eugène Lussier, garagiste, et Dasylva Léger, comptable, tous de Joliette, district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Faire le négoce de l'acier et autres produits métalliques; de toutes sortes de matériaux, de rebuts et ferrailles utilisables, sous le nom de \"Joliette Scrap Iron & Metal Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté'du bureau du Procureur général le vingt-quatre octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Kamet Tool & Die Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente octobre 1951, constituant en corporation: Samuel E.Schwisberg, Conseil en Loi du Roi, Cyril E.Schwisberg, avocat, tous deux d'Outremont, et Sonya Schneycr, secrétaire, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal.Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de machineries, appareils et outils d'usine, sous le nom de \"Kamet Tool & Die Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.,Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Laboratoire Bilophen Laboratory Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date dq issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lièrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fifth day of October, 1951, incorporating: Monique Couture, secrétaire, Lionel Lefebvre, accountant, and Cécile Lahaie, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in automobiles, motors and the accessories thereof, and operate garages, under the name of \"Jack Mignault Limitée\"', with a capital stock of S20.000 divided into 2,000 shares of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Joliette Scrap Iron & Metal Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date October twenty-fourth, 1951, incorporating Edouard Péloquin, tradesman, Eugène Lussier, garage-keeper, and Dasylva Léger, accountant, all of Joliette, judicial district of Joliette, for the following purposes: To deal in steel and other metal products; to deal in all kinds of materials, waste matter and usable scrap iron, under the name of \"Joliette Scrap Iron & Metal Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of October.1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Kamet Tool & Die Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of October, 1951, incorporating: Samuel E.Schwisberg, King's Counsel, Cyril E.Schwisberg, advocate, both of Outrement, and Sonya Schneyer, secretary, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of plant machinery, apparatus, tools, under the name of \"Kamet Tool & Die Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 preferred shares of $100.each and 200 common shares of S100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Laboratoire Bilopbcn Laboratory Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day 3360 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome S3, N° 50 vingt-six octobre 1951, constituant en corporation: Leopold Carle, médecin, Dame Marcelle Lefebvre, épouse dudit Leopold Carle, ménagère, etRaynald Lefebvre, employé civil, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme manufacturiers et commerçants de produits pharmaceutiques, sous le nom de \"Laboratoire Bilophcn Laboratory Inc.\", avec un capital de 820,000 divisé en 2,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.La Filature de l'Isle-Verte, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-trois octobre 1951, constituant en corporation: Léon Thériault, Lionel Thériault, Roger Thériault, industriels, Roland Thériault, gérant, Dame Eugénie Gamache Thériault, ménagère, épouse de Lionel Thériault, dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de l'Isle Verte, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie des matières textiles, sous le nom de \"La Filature de l'Isle-Verte, Limitée\", avec un capital de 8200,000 divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et en 1750 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à l'Isle Verte, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.of October, 1951, incorporating: Leopold Carle, physician, Dame Marcelle Lefebvre, wife of the said Leopold Carle, housewife, and Raynald Lefebvre, civil employee.all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To do business as manufacturers of and dealers in pharmaceutical products, under the name of \"Laboratoire Bilophen Laboratory Inc.\", with a capital stock of 820,000 divided into 2,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.La Filature de l'Isle-Verte, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of October, 1951, incorporating: Léon Thériault, Lionel Thériault, Roger Thériault, industrialists, Roland Thériault, manager, Dame Eugénie Gamache, Thériault, housewife, wife of Lionel Thériault, duly authorized by him for the purposes hereof, all of Isle-Verte, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To carry on the business of and deal in textile materials, under the name of \"La Filature de l'Isle-Verte, Limitée\", with a capital stock of 8200,000 divided into 250 common shares of $100 each and 1750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Isle-Verte, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of October, 1951.L.-DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.La Fonderie Paquette Foundry Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq octobre 1951, constituant en corporation: Joseph Hidola L'Abbé, surintendant, Jean L'Abbé, industriel, et Dame Carmel L'Abbé, garde-malade, épouse commune en biens de Jean L'Abbé, tous de Laprairie, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: , Manufacturer, forger, fondre, couler et faire le commerce de tous objets de fonte, d'acier, de cuivre, de bronze et autres métaux et alliages, sous le nom de \"La Fonderie Paquette Foundry Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair ou nominale de 100 chacune et en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair ou nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laprairie, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq octobre 1951.L'Assistant-procureur général.31627-0 L.DÉSILETS.La Fonderie Paquette Foundry Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of October, 1951, incorporating: Joseph Hidola L'Abbé, superintendent, Jean L'Abbé, industrialist, and Dame Carmel L'Abbé, nurse, wife common as to property of Jean L'Abbé all of Laprairie, judicial district of Montreal, for the following purposes:.To manufacture, forge, smelt, pour and deal in cast-iron, steel, copper, bronze and other \"metals and alloys, under the name of \"La Fonderie Paquette Foundry Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 preferred shares of a par or nominal value of $100 each and ino 100 common shares of a par or nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Laprairie, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.S3, No.50 3361 Laqucrrc & Frbre Ltée Avis est donné qu'en vertu de.la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRjche-lière conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deux octobre 1951, constituant en corporation: Taschereau Fortier, Guy Roberge, avocats, Hermance Felteau et Françoise Laperrièrc, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme commerçant de bois, sous le nom de \"Laquerre & Frère Ltée\", avec un capital de $60,000 divisé en 600 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val-Alain, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux octobre 1951.L'Assistant-procureur général.31627-Q L.DÉSILETS.Laquerre & Frcrc Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of October, 1951, incorporating: Taschereau Fortier, Guy Robergc, advocates, Hermance Fclteau and Françoise Laperrièrc, secretaries, all of the city and judicial district of Quebec, lor the following purposes: To do business as wood merchants, under the name of \"Laquerre & Frère Ltée\", with a capital stock of $60.000 divided into 500 shares of S100 each.The head office of the company will be at Val-Alain, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of October, 1951.L.DÉSILETS.31627 Deputy Attorney General.Le Cercle des Femmes Journalistes Incorporé Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-six octobre 1951.constituant en corporation sans capital-actions: Dame Laurc Cornez Hurtcau, épouse contrac-tuellement séparée de biens de Adolphe Hurtcau, avocat, et dûment autorisée par ce dernier,-aux fins des présentes, Gilberte Roby et Germaine Bcrnier, toutes journalistes, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Favoriser les relations et l'amitié entre les personnes qui pratiquent la profession du journalisme, sous le nom de \"Le Cercle des Femmes Journalistes Incorporé\".Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur Général, le vingt-six octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-o L.DÉSILETS.Le Service Social de Nicolet Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Monsieur le Chanoine Georges Dubuc.prêtre, supérieur du Séminaire de Nicolet, Monsieur l'abbé Raoul Rhéault, prêtre, professeur au Séminaire de Nicolet, et M.l'abbé Raoul Lallier, prêtre, procureur de l'évêché de Nicolet, tous de Nicolet, district judiciaire de Nicolet, pour les objets suivants: Secourir les enfants naturels, les personnes inadaptées, difficile, irrégulières et délaissées; et établir des organismes, centres et permanence appropriés, sous le nom de \"Le Service Social de Nicolet\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le Cercle des Femmes Journalistes Incorporé Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1911, bearing date the twenty-sixth day of October, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: DameLaureCorne/, Hurtcau, wife separate as to property by marriage contract of Adolphe Hurteau, advocate, and duly authorized by the latter for the purposes hereof, Gilberte Roby and Germaine Bernier, all journalists, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote relations and friendship among those practising the profession of journalism, under the name of \"Le Cercle des Femmes Journalistes Incorporé\".The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Le Service Social de Nicolet Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset.in conformity .with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of November, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: The Rev.Canon Georges Dubuc, priest, superior of the Nicolet Seminary, the Rev.abbé Raoul Rhéault, priest, professor at the Nicolet Seminary, and the Rev.abbé Raoul Lallier, priest, procure for the Bishop's Palace of Nicolet, all of Nicolet, judicial district of Nicolet, for the following purposes: To give assistance to foundlings, and to underprivileged, difficult, erratic and forsaken people; and to establish appropriate organizations, centres and permanent homes, under the name of \"Le Service Social de Nicolet\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000. 3362 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome S3, N° 50 Le siège social de la corporation sera à Nicolet, district judiciaire de Nicolet.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-o L.DÉSILETS.L'Hôtel National Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-sept octobre 1951, constituant en corporation: L.-Philippe Gagnon, dentiste, Gaston Ga-gnon, gérant, Victor Clouticr, médecin, Lucien Clouticr, négociant, et Maurice Lessard, garagiste, tous de Saint-Georges, de Beauce, district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtel, sous le nom de \"L'Hôtel National Limitée\", avec un capital de §75,000 divisé en 750 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Georges, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.The head office of the corporation will be at Nicolet, judicial district of Nicolet.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.L'Hôtel National Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Conrpanics' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of October, 1951, incorporating: L.Philippe Gagnon, dentist, Gaston Gagnon, manager, Victor Cloutier.physician, Lucien Clouticr, merchant, and Maurice Lessard, garage-keeper, all of Saint-Georges de Beauce.judicial district of Beauce, for the following purposes: To carry on the hotel business, under the name of \"L'Hôtel National Limitée\", with a capital stock of 875,000 divided into 750 shares of S100 each.The head office of the company will be at the town of St-Gcorges, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Maple Holdings Ltd.Maple Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Act.letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of theProvin-vince de Québec, représenté par M.C.Lallichc- ce of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, lière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-,*ffcS.Q.1941, bearing date the twenty-fourth day quatre octobre 1951, constituant en corporation: of October, 1951, incorporating: Karl Morgan-Karl Morganstern, manufacturier, Joyce Hogg, stem, manufacturer, Joyce Hogg, receptionist, réceptionniste et June Kirlin, secrétaire, tous des and June Kirlin, secretary, all of the city and ju-cité et district judiciaire de Montréal, pour les dicial district of Montreal, for the following pur-objets suivants: # poses: Transiger les affaires d'une compagnie d'im- To carry on the business of real estate and meubles et de portefeuille, sous le nom de \"Maple holdings company, under the name of \"Maple Holdings Ltd.\", avec un capital de S75,000 divisé Holdings Ltd.\", with' a capital stock of 875,000 en 600 actions privilégiées d'une valeur au pair divided into 600 preferred shares having a par dc 8100 chacune et 150 actions ordinaires d'une value of 8100 each, and 150 common shares valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31027 L.DÉSILETS.Matane Construction Limited Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compangies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt-trois octobre 1951, constituant en corporation: Georges Alexandre Lebel, notaire, Jean Lebel, comptable, et Eudora Forbes, sténographe, tous de la ville dc Matane, district judiciaire dc Rimouski, pour les objets suivants: Exercer les opérations de contraetcurs et entrepreneurs généraux, sous le nom dc \"Matane Construction Limited\", avec un capital de S40.000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-Q L.DÉSILETS.having a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Matane Construction Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty, third day of October, 1951, incorporating, Georges Alexandre Lcbel, notary, Jean Lcbel: accountant, and Eudorc Forbes, stenographer-all of the town of Matane, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Matane Construction Limited\", with a capital stock of S40.000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of October.1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.83, No.60 3363 Nérée Guérctte & Fils Ltée.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941 des lettres patentes, en date du vingt-sept octobre 1951, constituant en corporation: Jean-Marie Guérctte, Nérée Guérette, marchands dc Causapscal, district judiciaire de Rimouski, et Michel Motard, comptable, des cité et district de Québec, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de marchandises sèches, vêtements, épicerie, quincaillerie, sous le nom de \"Nérée Guérette & Fils Ltée\", avec un capital de $125,000 divisé en 500 actions privilégiées de $100 chacune, et en 750 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Causapscal, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général,-le vingt-sept octobre 1951.L'Assistant-procureur bénéral, 31627-o L.DÉSILETS.Nérée Guérette & Fils Ltée.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941.bearing date the twenty-seventh day of October, 1951, incorporating: Jean-Marie Guérette, Nérée Guérette, merchants, of Causapscal, judicial district of Rimouski, and Michel Motard, accountant, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in dry goods, clothing, groceries, hardware, under the name of \"Nérée Guérette & Fils Ltée\", with a capital stock of 8125,000, divided into 500 preferred shares of 8100 each, and 750 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Causapscal, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31027 Deputy Attorney General.Nicole Frères Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente octobre 1951, constituant en corporation: Laurent Nicole, comptable, Joseph Nicole, beurrier, et Dame Annette Langlois, Nicole, ménagère, épouse contractucllement séparée de biens de Laurent Nicole, tous de Val Brillant, district judiciaire dc Rimouski, pour les objets suivants: Faire affaires comme beurrier, laitier, fabricant de moidées, sous le nom de \"Nicole Frères Inc.\", avec un capital dc 890,000 divisé en 000 actions ordinaires de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val Brillant, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le trente octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31027-o .L.DÉSILETS.Nicole Frères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieut et ant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of October, 1951, incorporating: Laurent Nicole, accountant, Joseph Nicole, huttcr-makeiv.and Dame Annette Langlois Nicole, housekeeper and wife separate as to property of Laurent Nicole, all of Val Brillant, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To do business as butter-maker, dairyman, feed manufacturer, under the name of \"Nicole Frères Inc\"., with a capital stock of 890,000 divided into 000 common shares of S100 each, and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Val Brillant, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, the thirtieth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31(527 Deputy Attorney General.Packers Equipment & Service Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six octobre 1951, constituant, en corporation: Harold Conrad Walby, manufacturier, Anna Sofia Walby, ménagère, épouse séparée de biens de Harold Conrad Walby, et dûment autorisé par lui, Roi et Brunlanes Walby, manufacturier et Eric Christian Walby, vendeur, tous de la cité de Westmount et John Cranston Stark, vendeur, de la cité dc Montréal, tous du district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de machinerie et outillage employés dans l'empaquetage des produits alimentaires, accesoires pour boucher, quincaillerie et produits en fer et acier, sous le nom dc \"Packers Equipment & Service Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Packers Equipment & Service Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth clay of October, 1951, incorporating: Harold Conrad Walby, manufacturer, Anne Sofia Walby, housewife, wife separate as to property of Harold Conrad Walby, and duly authorized by him, Robert Brunlanes Walby, manufacturer, 'and Eric Christian Walby, salesman, all of the City of Westmount, and John Cranston Stark, salesman, of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in machinery and equipment used for the packing of food products, in butcher supplies, in hardware and iron an steel products under the name of \"Packers Equipment & Service Limited\", with a capital stock of S50,000 divided into 2,000 common shares of S10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of \"the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal. 3364 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 décembre 1951, Tome S3, N° 50 Daté du Bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Pel-Ba Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six octobre 1951, constituant en corporation: Louis Baillargeon, Jules Baillargcon, notaires, et Jacques Lemieux, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie d'immeubles et le commerce des produits de la mer, de la terre et des forêts, sous le nom de \"Pel-Ba Inc.\" avec un capital de 875,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 38, Desjardins, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Pharmacie Antonio Vcrmette Ltée Avis e3t donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq octobre 1951, constituant en corporation: Antonio Vermette, J.-Guillaume Charland, pharmacien chimistes, et J.-E.Morin, pharmacien chimiste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de produits chimiques, pharmaceutiques, instruments médicaux et chirurgicaux, sous le nom de \"Pharmacie Antonio Vermette Ltée\", avec un capital de 825,000 divisé en 2,500 actions dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq octobre 1951.L'Assistant-p rocu reu r général.31027-o L.DÉSILETS.Roslyn Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six octobre 1951, constituant en corporation: William Fraser Mackkier, avocat et Conseil en Loi du Roi, Edmond-Jacques Courtois, avocat, Ross Trenholme Clarkson, Edward Her-rick Knatchbull-Hugessen, avocats, et Catherine Sterling Rutlcdge, secrétaire, veuve, tous dés cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce 'd'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Roslyn Holdings Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth dav of October, 1951.L.DÉSILETS, 31027-o Deputy Attorney General.Pcl-Ba Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of October, 1951, incorporating: Louis Baillargeon, Jules Baillargeon, notaries, and Jacques Lemieux, accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company and deal in the products of the sea, the soil and the forest, under the name of \"Pel-Ba Inc.\", with a capital stock of 875.000 divided into 500 common shares of a par value of $100 each and 250 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at 38 Desjardins Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Pharmacie Antonio Vermette Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of October, 1951, incorporating: Antonio Vermette, J.Guillaume Charland, pharmacists and chemists, and J.E.Morin.pharmacist and chemist, all of the city and judicial-district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of chemical and pharmaceutical products, and to deal in medical and surgical instruments, under the name of \"Pharmacie Antonio Vermette, Ltée\", with a capital stock of 825,000 divided into 2,500 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth dav of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Roslyn Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of October, 1951, incorporating: William Fraser Macklaier, advocate and King's Counsel, Edmond-Jacques Courtois, advocate, Ross Trenholme Clarkson, Edward Herrick Knatchbull-Hugessen, advocates, and Catherine Stirling Rutledge, secretary, widow, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and holdings company, under the name of \"Roslyn Holdings Ltd.\".with a capital stock of 840,000 divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.83, No.60 3365 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1951.L'Assistant-procureur géné ral, 31627 L.DÉSILETS.Syndicat Industriel de St-Lin Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres- patentes, en date du vingt-cinq octobre 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Rodolphe Dclongchamp, Rodolphe Champagne, Dollard Joly, marchands, Olivier Moreau,, garagiste, Edmond Chartier, Eloi Prud'Homme, bouchers, Ovide Charette, propriétaire dc cinéma, Jean Villeneuve, gérant de banque, Reginald Brissette, hôtelier, et Alfred Dufresne, vendeur, tous de Saint-Lin, district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Grouper des membres dans le but de les intéresser au bien être et au développement dc la Ville de St-Lin des Laurentides et de ses environs, sous le nom dc \"Syndicat Industriel de St-Lin\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels de biens immobiliers que la corporation peut posséder est de §100,000.Le siège social dc la corporation sera à Saint-Lin-des-Laurentides, district judiciaire dc Joliette Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.*\u2022 Teinturerie Dorchester Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-cinq octobre 1951, constituant en corporation: Maurice Lagacé, avocat, Philip Nolan, teinturier, et Louise Morisset-Nolan, ménagère, épouse dudit Philip Nolan, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie de teinturier et nettoyeur, sous le nom de \"Teinturerie Dorchester Inc.\", avec un capital de §40,000 divisé en 400 actions de §100.chacune.Le siège social de la compagnie sera à 120, rue Dorchester, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-Q L.DÉSILETS.Trans -America Petroleums Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf octobre 1951, constituant en corporation: John Bumbray, Conseil en Loi du Roi, de ville Mont-Royal, Gaston Massie, Marcel Lajeunesse, Jean-Paul Cardinal, avocats et Thérèse Boissy, secrétaire, tous quatre de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of October, 1915.L.DÉSILETS, 31627-o Deputy Attorney General.Syndicat Industriel dc St-Lin Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fitfh day of October, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Rodolphe Dclongchamp, Rodolphe Champagne, Dollard Joly, merchants, Olivier Moreau, garage-keeper, Edmond Chartier, Eloi Prud'Homme, butchers, Ovide Charette.proprietor of a moving picture theatre, Jean Villeneuve, bank manager, Reginald Brissette, hotel-keeper, and Alfred Dufresne, salesman, all of Saint-Lin, judicial district of Joliette, for the following purposes: To assemble the members for the purpose of interesting them in the welfare and development of the Town of St-Lin des Laurentides and its surroundings, under the name of \"Syndicat Industriel de St-Lin\".The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is §100,000.The head office of the corporation will be at Saint-Lin-des-Laurentides, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth dav of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Teinturerie Dorchester Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of October, 1951, incorporating: Maurice Lagacé, advocate, Philip Nolan, dyer, and Louise Morisset-Nolan, housewife, wife of the said Philip Nolan, all of the-city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of dyer and cleaner, under the name of \"Teinturerie Dorchester Inc\"., with a capital stock of §40,000 divided into 400 shares of §100 each.The head office of the Company will be at 120 Dorchester Street, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Trans-America Petroleums Ltd.(No Personal Liability Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of October, 1951, incorporating: John Bumbray, King's Counsel, of the Town of Mount-Royal, Gaston Massie, Marcel Lajeunesse, Jean-Paul Cardinal, advocates, and Thérèse Boissy, secretary, all four of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: 33G6 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 83, N° 60 Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque manière que ce soit, le sol, la terre, les roches et les pierres dans le but d'en extraire des minerais quelconques, donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de ^'Trans-America Petroleums Ltd.\" (Libre dc responsabilité personnelle), avec un capital dc §4,000,000 divisé en 4.000,000 d'actions de 81 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social dc la compagnie sera â Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Ulric Binette & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-quatre octobre 1951, constituant en corporation: Ulric Binette, manufacturier.Ernest Binette, comptable, et Dame Georgiana Boutin, épouse commune en biens dudit Ulric Binette, dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de menuisier, ébéniste, meublier et décorateur, sous le nom de \"Ulric Binette & Fils, Inc.\", avec un capital de 8125,000 divisé en 1,000 actions privilégiées de 8100 chacune, et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc S25 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-quatre octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Prospect and explore for mines and minerais Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or, treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"Trans-America Petroleums Ltd.\" (No Personal Liability), with a capital stock of 84,000,000.divided into 4,000,000 shares of 81.each.The shareholders incur no personal responsibility in excecss of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares; The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.1 Ulric Binette & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fourth day of October, 1951, incorporating: Ulric Binette, manufacturer, Ernest Binette, accountant, and Dame Gcorgiana Boutin, wife common as to property of said Ulric Binette, authorized by him, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: mFo carry on the trade and business of joiner, cabinet-maker, furniture maker and decorator, under the name of \"Ulric Binette & Fils, Inc.\", with a capital stock of 8125,000 divided into 1,000 preferred shares of 8100 each, and into 1,000 common shares of a par value of 825 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627 .Deputy Attorney General.Viandes de choix, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux novembre 1951, constituant en corporation: Simon Lebœuf, commerçant, de Jonquièrc, Cléo-phas Girard, gérant d'Arvida, tous deux du district judiciaire dc Chicoutimi, et Philippe Du-chesnes, commerçant, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: ( Exercer le commerce de la viande et produits alimentaires, sous le nom de \"Viandes de Choix, Limitée\", avec un capital de S40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 800, rue Saint-Dominique, Conquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le deux novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS^ Viandes dc choix, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of November, 1951, incorporating: Simon Lebceuf, tradesman, of Jonquière, Cléophas Girard, manager, of Arvida, both of the judicial district of Chicoutimi, and Philippe Duchesnes, tradesman, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business in meats and to deal in food products, under the name of \"Viandes de Choix, Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company .will be at 800 Saint-Dominique Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this second, day of November, 1951.L.r DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol 83, No.50 3367 West End Furniture Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente octobre 1951, constituant en corporation: Harry Blank, avocat, June Kirlin et Joyce Hogg, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montreal pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de meubles et fournitures de maison, sous le nom de \"West End Furniture Co.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente octobre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.West End Furniture Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of October, 1951, incorporating: Harry Blank, advocate, June Kirlin and Joyce Hogg, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealing with furniture and house furnishings, under the name of \"West End Furniture Co.\", with a capital stock of S40,000.divided into 200 preferred shares having a par value of $100.each, and 200 common shaies having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirthieth day of October, 1951.L.DÉSILETS, 31627-0 Deputy Attorney General.Yvan Côté Limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit novembre 1951, constituant en corporation: Yvan Côté, entrepreneur électricien, Gaé-tan-J.Côté, Louis-Georges Carignan, ingénieurs professionnels, tous de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer le métier d'électricien et entrepreneur-électricien, de manufacturiers et commerçants d'appareils ou accessoires électriques, sous le nom de \"Yvan Côté Limitée\", avec un capital de S40.000 divisé en 1,000 action d'une valeur au pair de $40.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Yvan Côté Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Comapnies' Act, letters patent have been granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1951, bearing date the eighth day of November, 1951, incorporating: Yvan Côté, electrical-contractor, Gaétan J.Côté, Louis-Georges Carignan, professional engineers, all of the city of Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: To carry on the trade of electrician and of electrical contractor, of manufacturer of dealer in electrical apparatus or accessories, under the name of \"Yvan Côté Limitée\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of a par value of $40.each.The head office of the Company shall be in Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Zena Trading Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six octobre 1951, constituant en corporation: Munio Teicher, marchand, Abe Cohen, commis, et Sureka Wasserman, secrétaire, tous des cité, et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce de menus objets, joaillerie et vêtements, sous lenomde\"Zcna Trading Inc.\", avec un capital dc $40,000 divisé en 360 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 40 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1951.Zena Trading Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of October, 1951, incorporating: Munio Teichcr, merchant, Abe Cohen, clerk, and Sureka Wasserman, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: * To carry on the business and deal in and with small wares, jewellery and wearing apparel, under the name of \"Zena Trading Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 360 preferred shares of a par value of $100 caeh and 40 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of October, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 31627 L.DÉSILETS.31627-0 Deputy Attorney General. 3308 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC?Québec, 15 décembre 1951, Tome 83, N° 60 Lettres patentes supplémentaires Ciment Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chap.270, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 novembre 1951, à la compagnie \"Ciment Quebec Inc.\", ratifiant son règlement X: a) réduisant son capital-actions par l'annulation de 700 actions privilégiées de $50 chacune; b) subdivisant les 31,000 actions ordinaires sans valeur au pair en 0S.000 actions ordinaires sans valeur au pair; c) augmentant le capital-actions de la compagnie par la création de 2,000 actions ordinaires additionnelles sans valeur au pair, et de 20,000 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énumérés dans ledit règlement; d) fixant à SG50,000 le montant avec lequel la compagnie pourra continuer ses opérations à l'avenir.Daté du bureau du Procureur général, le 21 novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31027-o L.DÉSILETS.Gaspcsia Sulphite Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, des lèpres patentes supplémentaires en date du 24 novembre 1951, à la compagnie \"Gaspcsia Sulphite Company Ltd.\", ratifiant son règlement spécial AA augmentant son capital autorisé dc Si,000,000 à $0,000,000 par la création de 880,000 actions ordinaires additionnelles de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 24 novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31027 L.DÉSILETS.Gould Bros.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 23 novembre 1951, changeant le nom de la compagnie \"Darling Investments, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 13 décembre 1949, en celui de \"Gould Bros.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 23 novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627 L.DÉSILETS.Zenith Enterprises Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 22 novembre 1951, à la compagnie \"Zenith Building Products Company Limited - La Compagnie Zenith des Produits de Construction Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 février 1948, changeant son nom en celui de \"Zenith Enterprises Company Ltd.\" Supplementary Letters Patent Ciment Quebec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-first day of November, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Ciment Quebec Inc.\", ratifying its by-law No.X: a) decreasing its capital stock by the cancellation of 700 preferred shares of $50 each; b) subdividing the 34,000 common shares having no par value into 68,000 common shares without par value; c) increasing the capital stock of the company by the creation of 2,000 additional common shares having no par value, and 20.000 additional preferred shares of $100 each, subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law; d) fixing at $650,000 the amount with which the company may continue its operations in the future.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-first dav of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Gaspcsia Sulphite Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of November, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Gaspcsia Sulphite Company Ltd.\", ratifying its special by-law AA increasing its authorized capital stock from $1,600,000 to $6,000,000 by the creation of 880,000 additional common shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627-o Deputy Attorney General.Gould Bros.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Darling Investments, Limited\", incorporated bv letters patent dated December 13th, 1949, to that of \"Gould Bros.Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, the 23rd day of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627-o Deputy Attorney General.Zenith Enterprises Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-second day of November, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Zenith Building Products Company Limited - La Compagnie Zénith des Produits de Construction Limitée\", incorporated by letters patent dated the 14th of February, 1948, changing its name to that of \"Zenith Enterprises Company Ltd.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.S3, No.50 3369 Daté du bureau du Procureur général, le 22 novembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31627-0 L.DÉSILETS.Clubs \u2014 4-H Clubs, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de là province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 24 octobre 1949, à la corporation \"Clubs 4-H du Québec\", constituée sous l'empire de la troisième partie de ladite loi par lettres patentes du 28 avril 1944.changeant son nom en celui de \"Clubs \u2014 4-H \u2014 Clubs.Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 11 décembre 1951.L'Assistant-procureur général.31662-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of November, 1951.L.DÉSILETS, 31627 Deputy Attorney General.Clubs \u2014 4-H \u2014 Clubs, Inc.Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-fourth day of October, 1949, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the corporation \"Clubs 4-H du Quebec'^', incorporated under Part III of the said Act, by letters patent dated the 28th of April, 1944.changing its name to that of \"Clubs \u2014 4-H \u2014 Clubs, Inc.\" r Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31662 Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens Actions.for separation as to property avis lé( ;al legal notice Dame Elizabeth Erdely, ménagère, épouse Dame Elizabeth Erdcly, housewife, wife com-commune en biens de Ste Kernusz, entrepreneur mon as to property of Steve Kernusz, building en construction, domicilié à 3875 avenue Henri contractor, domiciled at 3875 Henri Julien Ave-Julien, en les cité et district de Montréal, a inten- nue, in the city and district of Montreal, has té contre son époux une demande en séparation taken an action against her husband for separa-de J)iens, suivant les dossiers de la Cour Supé- tion as to property, pursuant to the records of rieure, séant à Montréal, numéro 308637.the Superior Court, sitting at Montreal, number 308637.Montréal, 6 décembre 1951.Montreal, December 6.1951.Le Procureur de la demanderesse, (Signed) paul MASSÉ, 31628-o (Signé) paul MASSÉ.31628 Attorney for the plaintiff.Dame Jeannette Bouchard, épouse de A.Dame Jeannette Bouchard, wife of A.Trem-Tremblay, entrepreneur, tous deux domiciliés à blay, contractor, both domiciled at 4218 Ste-4218 rue Ste-Emilie, en les cité et district de Emélie Street, in the city and district of Mont-Montréal, a formé contre le défendeur, son mari, real has taken, against the defendant, her hus-une demande en séparation de biens, devant la band, an action for separation as to property, in l'our supérieure du district de Montréal, sous le the Superior Court of the district of Montreal, numéro 308047.under number 308047.-Montréal, ce 4 décembre 1951.Montreal, December 4, 1951.L'Avocat de la demanderesse, L.p.LARIVTÈRE, 31640-o l.-p.LARIVIÈRE.31640 Attorney for the plaintiff.Canada, Province de Québec, district de St- Canada, Province of Quebec, district of St.François, Cour Supérieure, N° 9570.Dame Ma- Francis, Superior Court, No.9576.Dame Marie-Rose Gagnon, de la cité de Sherbrooke, dis- rie-Rose Gagnon, of the city of Sherbrooke, district de St-François.épouse commune en biens trict of St.Francis, wife common as to property de Maurice Longpré, journalier, de la cité de of Maurice Longpré, labourer, of the city of Sherbrooke, district de St-François, demande- Sherbrooke, district of St.Francis, plaintiff, vs resse, vs Maurice Longpré, journalier, de la cité Maurice Longpré, labourer, of the city of Sher-de Sherbrooke, district de St-François.défendeur, hrooke, district of St.Francis.Une action en séparation de biens a été insti- An action in separation as to property has been tuée en cette cause le 29 novembre 1951.entered in this case, on the 29th .of November 1951.Sherbrooke, ce 5 décembre 1951.Sherbrooke, December 5th, 1951.** « L'Avocat de la demanderesse, FRANCOIS POULIN, advocate, FRANCOIS POULIN, avocat.Attorney for plaintiff.00, Wellington-Nord, Apt.2, 66 Wellington-North.Apt.2, Sherbrooke, P.Q.31655-0 Sherbrooke, P.Q.31655-o Canada, Province de Québec, District de Mont- Canada, Province of Quebec, District of Montréal, Cour Supérieure, N° 290503.De Marie real, Superior Court, No.290503.De Marie Chora Georgiana Marcotte, ménagère, épouse Chora Georgiana Marcotte, housewife, wife com-commune en biens de Adélard Dancosse, des cité mon as to property of Adélard Dancosse, of the et district de Montréal, demanderesse, vs Adélard city and district of Montreal, plaintiff, vs Adé-Dancosse, marchand de fruit, des cité et district lard Dancosse, fruit merchant, of the city and de Montréal.district of Montreal, defendant. 3370 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 décembre 1951, Tome 83, N° 60 Une action en séparation de biens a été intentée le 25 septembre 1950.Montréal, 25 septembre 1950.Le Procureur de la demanderesse, 31672 JOS.A.BUDYK.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1377 Québec, le 6 décembre 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant une modification au décret relatif aux employés de garage dans les cités de Québec, Lévis et les comtés de Québec, Lévis et Montmorency.Attendu que, conformément aux dispositions dc la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de garage dans les cités de Québec, Lévis et les comtés de Québec, Lévis et Montmorency, rendue obligatoire par le décret numéro 765 du 13 mai 1938, amendé par les arrêtés numéros 1746, 1747 et 2778 des 2 septembre et 23 décembre 1938, 361, 544, 801 et 802 des 25 février, 29 mars et 8 mai 1939, 2099, 3324, 4141 et 4199 des 27 mai 11 septembre, 27 et 28 novembre 1940, 899 du 15 avril 1942, 3747 du 17 décembre 1943, 3231 du 17 août 1945, 2299 du 12 juin 1946, 492-A du 21 mars 1947, 483-A et 867-G des 7 avril et 9 juin 1948, 976-A du 31 août 1949, 108-A du 25 janvier 1950 et 541-H du 30 mai 1951, ont présenté au Ministère du Travail une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 octobre 1951; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 765, soit modifié comme suit: Le dernier alinéa du paragraphe \"l-i\" de l'article IV (Établissements industriels \u2014 Zone I), est remplacé par le suivant: \"Livreur: Dans les établissements de juridic-tioiyndustrielle et commerciale, le livreur désigne tout salarié qui, avec une voiture automobile dont il a la charge, fait la livraison et le transport des marchandises; son salaire minimum est de $0.65 l'heure.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 31674-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF .Numéro 1377 Québec, le 6 décembre 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"/?\" An action in separation as to property has been instituted on the 25th of September 1950.JOS.A.BUDYK, 31672-0 Attorney for Plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1377 Quebec, December 6, 1951.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning an amendment of the decree relating to the garage employees in the cities of Quebec, Levis and the counties of Quebec, Levis and Montmorency.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the garage employees in the cities of Quebec, Levis and the counties of Quebec, Levis and Montmorency, rendered obligatory by the decree number 765 of May 13,1938, as amended by Orders Nos.1746, 1747 and 2778 of September 2 and December 23, 1938, 361, 544, 801 and 802 of February 25, March 29, and May 8, 1939, 2099, 3324, 4141 and 4199 of May 27, September 11, November 27 and 28, 1940, 899 of April 15, 1942, 3747 of December 17, 1943, 3231 of August 17, 1945, 2299 of June 12, 1946, 492-A of March 21, 1947, 483-A and 867-G of April 7 and June 9, 1948, 976-A of August 31, 1949,108-A of January 25, 1950, and 541-H of May 30, 1951, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree, as amended; Wheheas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of October 27.1951; Whereas no objection has been made against its approval; Be it enacted, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the said decree, number 765, be amended as follows: The last paragraph of subsection \"l-i\" of section IV (Industrial Establishments - Zone I), is replaced by the following: \"Delivery man: In the establishments of the* industrial and commercial jurisdiction, the delivery man shall be the employee who, with a motor vehicle of which he is in charge, does the delivery and transport of merchandise; his minimum wage rate shall be $0.65 per hour.\" (Document \"A\" annexed to the order) A.MORISSET, 31674-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1377 Quebec, December 6, 1951.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Part \"B\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.88, No.00 3371 Concernant une modification au décret relatif Concerning an amendment of the decree relat- aux métiers de plombier et poseur d'appareils ing to the plumbing and steamfitting trades in de chauffage dans les comtés de Hull, Gatineau, the counties of Hull, Gatineau, Papineau, Pon- Papineau, Pontiac, Labelle et Témiscamingue.tiac, Labelle and Tcmiscamingue.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus dc Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention dc proposer l'approbation d'une modification au décret numéro 749 du 27 mai 1948, amendé par les arrêtés numéros 1039-D du 4 août 1948, 514-C et 883-D des 12 mai et 11 août 1949, 850-G du 19 juillet 1950 et 926-E du 22 août 1951, relatif aux métiers de plombier et poseur d'appareils de chauffage dans les comtés de Hull, Gatineau, Papineau, Pontiac, Labelle et Témiscamingue; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle dc Québec, édition du 27 octobre 1951; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition dc l'honorable Ministre du Travail: Que le comté de Labelle soit radié de la juridiction territoriale décrite au paragraphe \"a\" dc l'article II dudit décret, numéro 749.(Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 3I074-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1377 Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), thfc Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of an amendment to the decree number 749 of May 27, 1948, as amended by Orders Nos.1039-D of August 4, 1948, 514-C and 883-D of May 12 and August 11, 1949, 850-G of July 19, 1950 and 926-E of August 22, 1951, relating to the plumbing and steamfitting trades in the counties of Hull, Gatineau, Papineau, Pontiac, Labelle and Témiscamingue; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette of October 27, 1951 ; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; Be it enacted, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the county of Labelle be stricken off the territorial jurisdiction described in subsection \"a\" of section II of the said decree, number 749.(Document \"B\" annexed to the Order) A.MORISSET, 31674-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Québec, le 6 décembre 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.' Present: Section \"C\" Number 1377 Quebec, December 6, 1951.The Lieutenant-Govemor-in-Council.Part \"0\" Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating à l'industrie de la botté de carton dans la région to the paper box industry in the district of Que-de Québec.bec.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton, juridiction de Québec, a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier le décret numéro 758 du 19 juillet 1951, relatif à l'industrie de la boîte de carton dans les districts judiciaires de Kamouraska, Montma-gny, Beauce, Arthabaska, Saint-François, Nicolet, Québec, Trois-Rivières, Roberval, Chicoutimi et Saguenay.Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 octobre 1951; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi ; .Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 758, soit modifié comme suit: Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article III: 1° A la fin de l'échelle des salaires minima apparaissent au paragraphe \"a\" (Salariées) : Taux horaires Travailleuse posant étiquettes à la main.SO.51 Mécanicienne de machine à poser les étiquettes.0.53 Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Parity Committee of the Paper Box industry, Quebec Jurisdiction, has submitted to the Minister of Labour a request to amend the decree number 758 of July 19, 1951, relating to the paper box industry in the judicial district of Kamouraska, Montmagny, Beauce, Arthabaska, St.Francis, Nicolet, Quebec, Three-Rivers, Roberval, Chicoutimi and Saguenay; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of October 27, 1951; Whereas the objection set forth has been considered as required by the Act; Be it enacted, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 758, be amended as follows: The following provisions are added to section III: 1.At the end of the minimum wage scale contained in subsection \"a\" (female employees): Hourly rates Handlabeller.SO.51 Labelling machine operator.0.53 3372 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 88, N° 50 2° A la fin de l'échelle des salaires minima apparaissant au paragraphe \"b\" (Salariées) : Mécanicien\"creaser\".SO.90 Préposé à la mise en train Stoke & Smith 0.86 Mécanicien dc machines non classifiécs.0.71 Préposé à la mise en train: Machine Ind- muii.0.86 Préposé à la mise en train: Machine à cirer.0.71 Préposé à la mise en train: machine automatique cellophane.0.94 Fileur, machine automatique cellophane 0.73 Mécanicien de machine à transporter et à empiler motorisée.0.76 Préposé à l'emballage et ficelage.0.66 Electricien.0.90\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 31674-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1377 Québec, le 6 décembre 1951.Présent : Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"/J\" Concernant une modification au déeret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité conjoint des métiers dc la construction de Montréal a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier le décret numéro 579 du 7 juin 1951, amendé par les arrêtés numéros 894-F, 1110-G, 1196-B et 1226-F des 14 août, 3, 25 et 31 octobre 1951, relatif à l'industrie et aux métiers dc la construction dans la région de Montréal; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle dc Québec, édition du 27 octobre 1951; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 579.soit modifié comme suit: Le paragraphe.\"*/\" de l'article XVII est remplacé par le suivant: \".S 5.00 $ 5.00 $ 5.00 3.Couturière \u2014 Seamstress.5.00 4.50 4.50 4.Employée de bureau, employée spécialisée, cuisinière \u2014 Office par heure \u2014 per hour employee, specialized employee, cook.0.50 0.45 0.44 5.Salariée non comprise dans les catégories précédentes \u2014 Employee not included in the foregoing categories.0.44 0.42 0.40' 7° A l'article XI (Salaire pour temps supplé- 7.In section XI (Wages for overtime), sub-mentaire), les paragraphes 1 et 2 seront rem- sections 1 and 2 will be replaced by the following: placés par les suivants: Zones I II III \"1.Mécanicien de machines fixes \u2014 Stationary engineman: par heure \u2014 per hour a) 2é classe \u2014 2nd class.$1.57^ $1.53 $1.53 b) 3e classe \u2014 3rd class.1.50 1.38 1.38 c) 4e classe \u2014 4th class.1.42}4 1.30^ 1 \u2022 30^ 2.Chauffeur \u2014Fireman.1.30^ 1-23 1.23 \" 8° A l'article XV, le paragraphe \"a\" sera 8.In section XV, subsection \"a\" will be remplacé par le suivant: replaced by the following: \"a) Dans les zones I et II, le sacristain ou \"a) In zones I and II, the secton or the verger bedeau est employé à temps complet et doit shall be employed on a full-time basis and shall recevoir le salaire hebdomadaire fixé à l'article receive the weekly wages established in section VII, sauf dans des cas spéciaux qui doivent être VII, except for special cases which shall be soumis au Comité paritaire et approuvés par submitted to the Parity Committee and approved ledit Comité et alors il est rémunéré au taux de by the said Committeee; then, he shall be remu- $0.75 dans la zone I et au taux de $0.70 dans nerated on an hourly basis of $0.75 in zone I or la zone II et selon le nombre d'heures de travail $0.70 in zone II and according to the number of qu'il accomplit habituellement par semaine.\" hours worked, habitually, per week.\" 9° Les articles XVI et XVII seront remplacés 9.Sections XVI and XVII will be replaced by par les suivants: the following: \"XVI.Le salarié pour lequel un salaire heb- \"XVI.Employees for whom weekly wages are domadaire est ci-haut fixé, a droit à ce salaire determined hereinabove, are entitled to such hebdomadaire, pourvu qu'il ait été requis de weekly wages, provided they have been required travailler quarante (40) heures durant la semaine to work forty (40) hours during the week, even et cela même s'il n'a pas travaillé chaque jour, if they have not worked every day.However, if Cependant, si ce salarié chôme volontairement, such employees wilfully abstain from work, their son travail est rémunéré en la manière établie à work shall be remunerated in the manner est ab- l'article XVII.\" lished in section XVH.\" \"XVII.Le salarié pour lequel un salaire heb- \"XVII.The employees for whom weekly wages domadaire est ci-haut fixé, s'il n'a pas été requis are stipulated hereinabove, if they have not been de travailler durant quarante (40) heures en une required'to work during forty (40) hours in the semaine, pour chaque jour de travail, a droit course of a week and every working day, are à un sixième (1/6) du salaire hebdomadaire ci- entitled, per working day, to one-sixth (1/6) of haut fixé et, pour chaque heure, au prorata the weekly wages stipulated hereinabove, and per horaire du même salaire.\" hour, to the hourly prorata of the same wages.\" Chapitre 4 Chapter 4 Dispositions relatives aux heures de travail 10° A l'article XXIV (Employés réguliers), les paragraphes 2, 4 et 5 seront remplacés par les suivants: \"2.de cinquante (50) heures pour les mécaniciens de machines fixes et les chauffeurs.Toutefois, les heures supplémentaires de travail, jusqu'à concurrence de six (6) heures par semaine, ne sont pas considérées comme temps supplémentaire et sont payables aux taux réguliers prévus à l'article VII\"; Provisions relating to'kours of work 10.In section XXIV (Regular employees), subsection 2, 4 and 5 will be replaced by the following: \"2.made up of fifty (50) hours for stationary enginemen and* firemen.However, overtime hours, to the extent of six (6) per week, are not considered as overtime and paid for at the regular rate determined in section VII;\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.88, No.60 3391 \"4.de cinquante (50) heures, réparties en six (6) jours, pour les infirmiers\"; \"5.de cinquante (50) heures pour les autres salariés, des deux sexes, assujettis au décret.\" Chapitre 5 Dispositions relatives aux congés, aux jours chômés et aux vacances 11° A l'article XXX (Vacances payées), les paragraphes suivants seront ajoutés: \"6.Période de service continu donnant droit au congé.Pour chaque congé annuel payé, la période de service continu pour un employeur donnant droit à un tel congé, s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année subséquente.7.Indemnité en cas de renvoi ou départ.Tout salarié congédié ou qui quitte son emploi a droit, à son départ, à une indemnité équivalente à une demi-journée dc travail, par mois de calendrier .le service depuis le 1er mai précédant la date de son départ.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication dc cet avis dans la Gazette officielle iand sold by the said deed is described as follows: \"The land required to build a dam on the \"Rivière-à-la-Blague\", according to the plan of Mr.A.A.Beauchemin\".A farm measuring about five perches in width by seven arpents in depth, bounded on the north by the land of Magloire Chabot, on the northeast by the land of Thomas Chabot, on the south by numbers six hundred and eighty-five and six hundred and eighty-seven (685-687) oi-said cadastre, and the land of Wilfrid Morin, on the southwest by the land of Wilfrid Morin, and forming part of lots numbers six hundred and eighty-three and six hundred and eighty-six (683-686) on the official cadastral plan and in the book of reference for the parish of Saint-Thomas de Montmagny.Save to be deducted from said lot number six hundred and eighty-three (683) aforesaid the land described in the deed of sale and assignment by Dame Adélard Isabelle to the Water Supply Company, before notary L.D.E.Rousseau, on the thirteenth day of the month of November, one thousand nine hundred and five, and registered on the twenty-eight day of November, one thousand nine hundred and five, under number 18813, a deed establishing a servitude for the laying and maintaining in perpetuity a water supply, and the land sold in the said deed is described as follows: \"A lot of land of rectangular figure comprising the springs and measuring thirty-five feet from north to south and ninety feet from east to west, to be taken at ten feet from the farm of Albert Collin, or representatives, and forming part of lot number six hundred and eighty-three (Pt.683) of the aforesaid cadastre for Saint-Thomas de Montmagny.A wooded lot of land measuring five and one half perches in front, forming part of lot number seventeen-a (17A) in the second range of official cadastre for the township of Ashburton, bounded on the north and south by the \"trait-carrés\", on the northeast by the land of Wilfrid Morin, on the southwest by that of Adélard Collin; (Parish of N.D.du Rosaire).Lot number seven hundred and thirty-four (734) of the cadastre for Saint-Thomas de Montmagny, having a superficial area of fourteen arpents and ninety-five perches - and dependencies.Lot number seven hundred and thirty-one ,of the aforesaid cadastre containing sixteen arpents in superficial area - and dependencies.A lot of land measuring thirteen perches in front, by fifteen arpents in depth, more or less, bounded on the northeast by Théophile Tondreau, on the southwest by the representatives of Louis Gaudreau, on the north and south by the summit of the first crag there encountered, and forming part of lot number seven hundred and thirty-eight (Pt.738), of the aforesaid cadastre - and dependencies.A lot of land measuring fourteen perches/ in front, by fourteen arpents in depth, the whole without warranty as to exact measurement, the said land being bounded on the west by Théophile Tondreau, on the east by lot 731.on the 3406 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 83, N° 60 qui s'y rencontre et est connu et désigné comme faisant partie du lot sept cent vingt-trois (Ptie 723) du cadastre de St-Thomas de Montmagny, sans bâtisse.*\\ Une terre à bois connue sous le numéro mille vingt et un (1021) du cadastre de St-Thomas de Montmagny, quatrième concession, ayant un demi arpent de front sur la profondeur de la concession, le tout plus ou moins, le plus ou moins étant au bénéfice de l'acquéreur.Une terre à bois formant partie du lot huit cent cinq (Ptie 805) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Cap St-Ignace, borné au nord au terrain de Nazaire Proulx, au nord-est à celui d'Amédée Marois, et celui de Léon Mathieu, au sud à la quatrième concession et à l'ouest au terrain d'Arsène Gaudreau, sans garantie de mesure précise.Un certain terrain en ladite paroisse de Cap St-Ignace, en la troisième concession dc ladite paroisse, contenant un demi arpent de front sur environ vingt-cinq arpents de profondeur, borné à l'est au terrain de Joseph Coulombe, à l'ouest au dit acquéreur, au nord à celui d'Alyre Deladuran-taye, et au sud à la quatrième concession, formant partie du lot huit cent cinq (Ptie 805) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Cap St-Ignace.Une terre à bois située en la paroisse de Notre-Dame du Rosaire et bornée au nord-est au terrain de Price Brothers Co., Limitée, ou représentants et à l'ouest à celui de l'acquéreur sur la profondeur de la concession et connue et désignée comme partie du lot dix-sept a (Ptie 17A) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le deuxième rang (2) du Canton Ashburton.(Paroisse de N.-D.du Rosaire).Tous les droits de l'emprunteur sur le lot numéro dix-sept a (Pte 17A) dans le deuxième rang aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le canton Ashburton, et borné au nord et au sud par les fronteaux des rangs, à l'est par le terrain de l'acquéreur, et à l'ouest à celui de Rosaire Chabot, tel que le tout se trouve actuellement, le dit terrain vendu contenant environ onze perches de largeur.(Paroisse de N.-D.du Rosaire).En vertu d'un jugement accordé par la Cour Supérieure, Montmagny, en date du trentième (30ème) jour de novembre, 1951, ces immeubles seront vendus en bloc.Pour être vendus au bureau du Shérif, au Palais de Justice, à Montmagny, P.Q., le MERCREDI, SEIZIÈME jour (16ème) de JANVIER 1952, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.AD.BERNIER.Montmagny, le 3 décembre 1951.31652-50-2-o MONTRÉAL Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure, District de Montréal Montréal, à savoir: ( LAIDE PERRAS, de-N° 291123 < ^mandeur.ès-qualité, vs ( DAME GERMAINE ROY épouse séparée de biens de Julien Roy, défenderesse.Un emplacement situé à Plage Laval, comté de Laval, connus comme étant les lots numéros-trois cent soixante-trois, trois cent soixante-qua- south and north by the summit of a crag there encountered, and known and designated as forming part of lot seven and twçnty-three (Pt.723) on the cadastre for Saint-Thomas de Montmagny - without buildings.A wooded lot of land known as number one thousand and twenty-one (1021) of the cadastre for Saint-Thomas de Montmagny, fourth concession, measuring one half arpent in front, by the depth of the concession, the whole more or less, the more or less being to the benefit of the purchaser.A wooded lot of land forming part of lot eight hundred and five (Pt.805) on the official cadastral plan and in the book of reference for the parish of Cap St-Ignace, bounded on the north by the land of Nazaire Proulx, on the northeast by that of Amédéc Marois, and that of Léon Mathieu, on the south by the fourth concession and on the west by the land of Arsène Gaudreau, without warranty as to exact measurement.A certain lot of land in the said parish of Cap St-Ignace, in the third concession of the said parish, measuring one half arpent in front by about twenty-five arpents in depth, bounded on the east by the land of Joseph Coulombe, on the west by the said purchaser, on the north by that of Alyre Deladurantaye, and on the south by the fourth concession, and forming part of lot eight hundred and five (Pt.805) on the official cadastral plan and in the book of reference for the parish of Cap St-Ignace.A wooded lot of land situate in the parish of Notre-Dame du Rosaire and bounded on the northeast by the land of Price Brothers Co., Limited, or representatives and on the west by that of the purchaser, by the depth of the concession, and known and designated as part of lot seven-teen-a (Pt.l7A) on the official cadastral plan and in the book of reference for the second range (2) of the Township Ashburton (Parish of N.D.du Rosaire).All the rights of the borrower on lot number seventeen-a (Pt.l7A) in the second range on the official cadastral plan anil book of reference for the Township Ashburton, and bounded on the north and south by the \"fronteaux\" of the ranges, on the east by the land of the purchaser, and on the west by that of Rosaire Chabot, as the whole presently subsists, the said land sold containing about eleven perches in width.(Parish of N.D.du Rosaire.) In virtue of a judgment rendered by the Superior Court, Montmagny, bearing date the thirtieth (30th) day of November, 1951, the said immoveables will be sold \"en bloc\".To be sold at the Sheriff's Office, Court House, at Montmagny, P.Q., on WEDNESDAY, the SIXTEENTH (16th) day of JANUARY, 1952, at TWO o'clock in the afternoon.J.AD.BERNIER, Sheriff's Office.Sheriff.Montmagny, P.Q., December 3, 1951.31652-50-2 MONTREAL Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: / LAUDE PERRAS, plain-No.291123 < v-1 tiff ès-qualité; vs DAME (GERMAINE ROY, wife separate-as to property of Julien Roy, defendant.An emplacement situate at Plage Laval, county of Laval, known as lots numbers three hundred and sixty-three, three hundred and sixty-four and three hundred and sixty-five of the subdivision of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1951, Vol.83, No.50 3407 tre et trois cent soixante-cinq de la subdivision du lot cent quatre vingt-cinq (185-363-364-365) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Rose.Avec bâtisses dessus érigées, portant le numéro 112,12ème Avenue à Plage Laval.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Théophile de Laval, (Plage Laval) le VINGT-SEPTIÈME jour de DÉCEMBRE prochain, à ONZE heures du matin.Un dépôt de $500 sera exigé de tout offrant ou enchérisseur, suivant jugement de l'Hon.juge E.Marier, daté le 1er juin 1951.Le Shérif, CAISSE & HURTEAU.Bureau du Shérif, Montréal, 21 novembre 1951.31538-47-2-o lot one hundred and eighty-five (185-363-364-365) of the official plan and book of reference for the parish of Ste-Rose - with buildings thereon erected, bearing number 112, 12th Avenue, Plage Laval.To be sold at the parochial church door of the parish of St-Théophile de Laval (Plage Laval) on the TWENTY-SEVENTH day of DECEMBER next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.A deposit of $500 shall be exacted from each and every bidder pursuant to a judgment of Hon.Justice E.Marier, dated June 1st, 1951.CAISSE & HURTEAU, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal, November 21st, 1951.31538-47-2-o RIMOUSKI Fieri Facias Cour de l'Échiquier du Canada Ottawa \u2014 Province d'Ontario N° 35313 j T E ROI, dans l'affaire de l'impôt ) 1\u2014* sur le revenu et des amendements, demandeur; vs LÉONARD GAGNON, de Saint-Eugène de Ladrière, comté de Rimouski, défendeur.Les lots P.626, 627.P.628, au cadastre de Saint-Eugène de Ladrière, contenant en tout 300 acres plus ou moins, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de Saint-Eugène de Ladrière, le QUINZE JANVIER 1952, à DEUX heures de l'après-midi, heure solaire.Le Shérif, 31663-50-2-o CHARLES GARON.Fieri Facias Ottawa \u2014 Province d'Ontario Cour d'Échiquier du Canada N° 29806.< t E ROI dans l'affaire de l'Impôt \\ sur le Revenu et des amendements, vs DR.FLORIAN DROUIN, M.D., de Lac-au-Saumon, comté de Matapédia, P.Q., défendeur.Partie du lot N° 31, rang 1, du canton Amqui, étant un terrain d'environ 88 pieds sur 55 pieds plus ou moins, tel que clôturé, au cadastre officiel de Lac-au-Saumon, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Aucune offre moindre de $7,000.00 sera acceptée.Pour être vendu à la porte de l'église de Lac-au-Saumon de Matapédia, le SEIZE JANVIER, 1952, à ONZE heures A.M., heure avancée.Le Shérif, 31650-50-2-o CHARLES GARON.ROUYN-NORANDA Fieri Facias de Terris Canada, Province de Québec District de Rouyn-Noranda Cour supérieure ('T'HE NORTHER LIFE AS-àRouyn { J- SURANCE COMPANY N° 2572 (.OF CANADA, demanderesse, vs PETER BARTMAN, de Rouyn, P.Q., défendeur.\"Les immeubles suivants Le lot portant le numéro 126 du Bloc 159 aux plan et livre de renvoi officiel du Canton de Rouyn avec toutes les bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.\" RIMOUSKI Fieri Facias Exchequer Court of Canada Ottawa \u2014 Province of Ontario No.35313 ) nrHE KING, in the matter of the / * Income Tax Act and amendments, plaintiff; vs LEONARD GAGNON, of Saint-Eugène de Ladrière, county of Rimouski, defendant.Lots Pt.626, 627, Pt.628, of the cadastre for Saint-Eugène de Ladrière, containing in all 300 acres, more or less \u2014 with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold, at the church door of Saint-Eugène de Ladrière, on the FIFTEENTH day of JANUARY, 1952, at TWO o'clock in the afternoon, Standard Time.CHARLES GARON, 31663-50-2 Sheriff.Fieri Facias Ottawa \u2014 Province of Ontario Exchequer Court of Canada No.29806.\\ npHE KING (in the matter of the / Income Tax Act and amendments); vs DR FLORIAN DROUIN, M.D., of Lac-au-Saumon, county of Matapédia, P.Q., defendant.Part of lot No.31, range 1, of the township Amqui, being a lot of land of about 88 feet by 55 feet more or less, as fenced in, of the official cadastre for Lac-au-Saumon - with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.No offer less than $7,000.00 will be accepted.To be sold at the church door of Lac-au-Saumon of Matapédia, on the SIXTEENTH of JANUARY, 1952, at ELEVEN o'clock A.M., daylight saving time., CHARLES GARON, 31650-50-2 Sheriff.\" ROUYN-NORANDA Fieri Facias de Terris Canada, Province of Quebec District of Rouyn-Noranda Superior Court, /HTHE NORTHER LIFE AS-at Rouyn, < * SURANCE COMPANY No.2572 (OF CANADA, plaintiff, vs PETER BARTMAN, of Rouyn, P.Q.defendant.\"The following immoveables: Lot bearing number 126 of Block 159 on the official cadastral plan and in the book of reference for the township of Rouyn with all the buildings there on erected, circumstance and appurtenances\". 3408 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 83, N° 50 Pour être vendu à la porte de l'église de l'Immaculée Conception de Rouyn, P.Q., JEUDI le VINGT-SEPTIÈME jour de DÉCEMBRE 1951, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérjf, Bureau du shérif, J.H.CHARBONNEÀ.U.Rouyn, le 21 novembre 1951.31539-47-2-o [1ère insertion le 24 novembre 1951] To be sold at the church door of l'Immaculée Conception of Rouyn, P.Q., THURSDAY, the TWENTY-SEVENTH day of DECEMBER 1951, at TEN o'clock in the forenoon.J.H.CHARBONNEAU, Sheriff's Office, i Sheriff.Rouyn, November 21st, 1951.1 31539-47-2-o [First insertion November 24th, 1951] Arrêté en Conseil Order in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 1396 Number 1396 Québec, le 13 décembre 1951.Quebec, December 13, 1951.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Section \"C\" Part \"C\" Concernant une modification au décret relatif Concerning an amendment of the decree relating à l'industrie du camionnage dans l'Ile de Mont- to the trucking industry in the Island of Montréal, real.Attendu que, conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi dc la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation d'une modification au décret numéro 913 du 16 juin 1948, amendé par les arrêtés en conseil numéros 514-E du 12 mai 1949, 368-B du 6 avril 195:, 93-A et 1282-A des 25 janvier et 15 novembre 1951, relatif à l'industrie du camionnage dans l'Ile de Montréal; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 3 novembre 1951; Attendu Qu'une objection a été formulée et qu'elle a été appréciée conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail : Que ledit décret, numéro 913, soit modifié comme suit: Le paragraphe \"a\" de l'article IV est remplacé par le suivant: \"a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux salariés ci-après, à compter de la date de la publication du présent décret d'amendement dans la Gazette officielle de Québec: A l'embau- Après chage 2 mois Aide-junior.$0.45 $0.50 Est considéré comme \"aide-junior\" une personne de pas plus de 18 ans qui surveille mais ne transporte pas de marchandises pesant plus de 60 livres.A l'embau- Après Après chage 2 mois 6 mois Aide général.$.073 $0.76 S0.78 Manutenteur de fret.0.87 0.90 0.92 Homme d'entrepôt.0.87 0.90 0.92 Vérificateur.0.87 0.90 0.92 Chauffeur.0.88 0.91 0.93 Chauffeur semi-remorque 0.93 0.96 0.98\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 31674-0 Greffier du Conseil Exécutif.Whereas, pursuant to the procedure provided for under section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of an amendment to the decree number 913 of June 16, 1948, as amended by Orders in Council 514-E of May 12, 1949, 368-B of April 6, 1950, 93-A and 1282-A of January 25, and November 15, 1951.relating to the trucking industry in the Island of Montreal; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of November 3, 1951; Whereas one objection has been made and it has been considered as required by the act; Be it en a cet d, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the said decree, number 913, be amended as follows: \u2022 Subsection \"a\" of section IV is replaced by the following: \"a) The following minimum wage rates shall be paid to the employees hereafter mentioned, from the date of publication of the present amending decree in the Quebec Official Gazette.Start After at 2 months Junior Helper.$0.45 $0.50 A junior helper shall be a person of not more than eighteen (18) years of age not handling commodities over sixty pounds.Start After After at 2 months 6 months Helper (General).$0.73 SO.76 $0.78 Dockman.0.87 0.90 0.92 Warehouseman.0.87 0.90 0.92 Checker.0.87 0.90 0.92 Chauffeur.0.88 0.91 0.93 Chauffeur-Semi-Trailer.0.93 0.96 0.98\" I (Document \"C\" annexed to the order) A.MORISSET, 31674-0* Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 15th, 1961, Vol.83, No.50 3409 Index de la Gazette officielle it Québec, If 50 Actions en\" séparation de biens: Bouchard vs Tremblay.3369 Erdely vs Kernusz.3369 (iagnon vs Longpré.3369 Marcotte vs Dancosse.3369 Arrêtes en Conseil: 1377, section \"A\" \u2014 Employés de garage dans les cités de Québec, Lévis et al.1377, section \"B\" \u2014 Métiers de plombier et poseur d'appareils de chauffage dans les comtés de Hull, Gatineau et al.1377, section \"C\" \u2014 Industrie de la boîte de carton dans la région de Québec.1377, section \"D\" \u2014 Industrie et métiers de la construction dans la région de Montréal.1396, section \"C\" \u2014 Industrie du camionnage dans l'Ile de Montréal.Avis aux intéressés: Avis divers: Index ef the Quebec Official Gazette, No.50 Actions for Separation as to Property: Bouchard vs Tremblay.3369 Erdely vs Kernusz.3369 Gagnon vs Longpré .3369 Marcotte vs Dancosse.3369 Orders in Council: 1377, part \"A\" \u2014 Garage employees in 3370 the cities of Quebec, Levis et al.3370 1377, part \"B\" \u2014 Plumbing and steamfitting trades in the counties of Hull, 3370 Gatineau, et al.3370 1377, part \"G\" \u2014 Paper box industry 3371 in the district of Quebec.3371 1377, part \"D\" \u2014 Construction industry and trades in the district of Mont- 3372 real.3372 1396, part \"C\" \u2014 Trucking industry in 3408 the Island of Montreal.3408 3353 Notice to Interested Parties: 3353 Miscellaneous Notices: Association des Employés Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses des Comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (portion sise sur l'Ile Jésus) et Terrebonne (Formation).3372 Association des Maîtres Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses des Comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (portion sise sur l'Ile Jésus) et Terre-bonne (Formation).3373 Ausable Mines Limited (Directeurs).3374 Bills sanctionnés.3375 Conseil Supérieur de la Coopération (Règlement)».:.3377 Gingras, Bernard (Membre).3376 Goldner, Moe (Membre).3374 La Caisse Populaire de St-Jean Baptiste (Drummond) (Fondation).3373 La Chambre de Commerce Junior de St-Ferdinand (Changement de nom).3377 La Commission Industrielle de Saint-Jérôme \u2014 The Industrial Commission of St.Jérôme (Règlements).3376 Le Syndicat de l'Industrie de la Boulangerie Incorporé, Québec (Changement de nom).3377 Liste des présidents d'élection.3376 Marché d'Orléans, Inc.(Directeurs).3376 Marois Shoe Manufacturing Corporation (Directeurs).3373 Paul Guilbault Inc.(Directeurs).3378 Rioux & Pettigrew, Limitée (Directeurs) 3374 Syndicat Coopératif de St-René Goupil de Marsboro (Fondation).3373 Syndicat des Employés de Buanderies et Nettoyeurs pour le district de Montréal \u2014 The Laundry Workers and Cleaners' Syndicate for the District of Montreal (Formation).3374 Syndicat des Producteurs de Lait de Dupuy (Fondation).3374 The Lac Marois District Association Inc.(Règlements).3378 Trochu, Louis (Membre).3374 Association des Employés Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses des Comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (portion sise sur l'Ile Jésus) et Terrebonne (Formation).3372 Association des Maîtres Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses des Comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (portion'sise sur l'Ile Jésus) et Terre-bonne (Formation).3373 Ausable Mines Limited (Directors).3374 Bills sanctioned.3375 Conseil Supérieur de la Coopération (By-Law).3377 Gingras, Bernard (Member).3376 Goldner, Moe (Member).3374 La Caisse Populaire de St-Jean Baptiste (Drummond) (Foundation).3373 La Chambre de Commerce Junior de St-Ferdinand (Change of name) .3377 La Commission Industrielle de Saint-Jérôme\u2014 The Industrial Commission of St.Jérôme (By-Laws).3376 Le Syndicat de l'Industrie de la Boulangerie Incorporé, Québec (Change of name).3377 List of returning-officers.3376 Marché d'Orléans, Inc.(Directors).3376 Marois Shoe Manufacturing Corporation (Directors).3373 Paul Guilbault Inc.(Directors).3378 Rioux & Pettigrew, Limitée (Directors) 3374 Syndicat Coopératif de St-René Goupil de Marsboro (Foundation).:.3373 Syndicat des Employés de Buanderies et Nettoyeurs pour le district de Montréal \u2014 The Laundry Workers and Cleaners' Syndicate for the District of Montreal (Formation).3374 Syndicat cfés Producteurs de Lait, de Dupuy (Foundation).'.3374 The Lac Marois District Association Inc.(By-Laws).3378 Trochu, Louis (Member).3374 3410 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1961, Tome 83, N° 60 Chartes \u2014 Abandon de: Canada Baskets Limitée \u2014 Canada Baskets Limited.Darwood Mining Company.Eastern Engraving Company Limited.Compagnie autorisée à faire des affaires: Charters \u2014 Surrender of: Canada Baskets Limitée \u2014 Canada 8378 Baskets Limited.3378 3378 Darwood Mining Company.3378 3378 Eastern Engraving Company Limited .3378 Company Licensed to do Business: Continental Oil Company of Canada Limited.3379 Demandes à la Legislature: Biron, Succession Edouacd,.3879 Cappiello, Leo.3881 Centre Médical Clauâç Bernard Médical Centre.3380 Chicoutimi, cité de.3879 Dolbeau, ville de.3381 Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus.3381 Mayer, André.3379 Salaberry-de-Valleyfield, cité de.3380 St-Jérôme, cité de.3381 Thibert, Jean-Noel-A.3381 DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Affaires Municipales: St-Philippe, paroisse de.3382 Instruction publique: Municipalité scolaire de: Hauterive.3383 Kiamika.3382 St-Apollinaire.3383 St-Wilfrid-de-Barnston.3382 Continental Oil Company of Canada Limited.3379 Applications to Legislature: Bùoxl Brta* of Edouard.3379 Cappiello, Lta-.3381 Cent» Médkal Claud* Bernard Medical Cent»».3880 Chicoutimi, city of.3379 Dolbeau, town of.3381 Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus.3381 Mayer, André.3379 Salaberry-de-Valleyfield, city of.3380 St-Jérôme, city of.3381 Thibert, Jean-Noel-A.3381 DEPARTMENTAL NOTICES: Municipal Affairs: St-Philippe, parish of.3382 Education: School Municipality of : Hauterive.3383 Kiamika.3382 St-Apollinaire.3383 St-Wilfrid-de-Barnston.3382 Terres et Forêts: Service du Cadastre: Ascot, canton de.3383 Potton, canton de.3384 Ste-Rose, village de.3383 Travail: Lands and Forest: Cadastral Branch: Ascot, township of.3383 Potton, township of.*.3384 Ste-Rose, village of.3383 Labour: Comité paritaire de l'industrie de la botte de carton de la province de Québec (Modification).3391 Comité paritaire de l'industrie de la boulangerie et de la pâtisserie de Granby (Prélèvement).3386 Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Roberval (Approbation de règlements).3385 Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Roberval (Prélèvement).3384 Industrie de la confection pour hommes et garçons dans la province de Québec (Modification).3394 Institutions religieuses, hôpitaux et institutions d'enseignement dans la région de St-Hyacinthe (Modification) 3387 Greffe de notaire: Joint Committee of the Paper Box Industry of the Province of Quebec (Amendment).Parity Committee of the Baking and Pastry-Making Industry of Granby (Levy).Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of Roberval County (Approval of by-laws).Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of Roberval County (Levy).Men's and boys' clothing industry in the Province of Quebec (Amendment) .Religious institutions, hospitals and educational establishments of St.Hyacinthe and vicinity (Amendment) Notarial Record: Tremblay, Chs-Ed., en faveur dé*.3397 Tremblay, Chs-Ed., in favour of.Lettres patentes: Letters Patent: 3391 3386 3385 3384 3394 3387 3397 Allan Singer Limited.3354 Barraute Lumber Co.Ltd.3355 Allan Singer Limited.3354 Barraute Lumber Co.Ltd.3355 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 16th, 1951, Vol.83, No.60 3411 Berger de Paris Ltée.3355 Canada Door Installers Ltd.3355 Charlotte Limited.3356 Club de Hockey Lachine Rapides.3356 Desroches & Frères Inc.3356 Éditions J.Dupuis, Fils & Cie Inc.3357 Empire Electric Supply Company (Correction).3397 Fourrures Belmont Inc.3357 Frank A.Patrick Limited.3357 Garage National de St-Georges Incorporée.3358 Hôpital Voghel Inc.3358 J.A.Angel & Son Ltd.3358 Jack Mignault Limitée.3358 Joliette Scrap Iron & Metal Ltd.3359 Kamet Tool & Die Ltd.3359 Laboratoire Bilophen Laboratory Inc.3359 La Filature de l'Isle-Verte, Limitée____ 3360 La Fonderie Paquette Foundry Inc.3360 Laquerre & Frère Ltée.3361 Le Cercle des Femmes Journalistes Incorporé.3361 Le Service Social de Nicolet.3361 L'Hôtel National Limitée.3362 Maple Holdings Ltd.3362 Matane Construction Limited.3362 Nérée Guérette & Fils Ltée.3363 Nicole Frères Inc.3363 Packers Equipment & Service Limited.3363 Pel-Ba Inc.3364 Pharmacie Antonio Vermette Ltée .3364 Roslyn Holdings Ltd.3364 St-Jean, cité de.3397 Syndicat Industriel dc St-Lin.3365 Teinturerie Dorchester Inc.3365 Trans-America Petroleums Ltd.3365 Ulric Binette & Fils, Inc.3366 Viandes de Choix, Limitée.3366 West End Furniture Co.3367 Yvan Côté Limitée.3367 Zena Trading Inc.3367 Lettres patentes supplémentaires: Ciment Québec Inc.3368 Clubs \u2014 4-H \u2014 Clubs, Inc.3369 Gaspesia Sulphite Company Ltd.3368 Gould Bros.Ltd.3368 Zenith Enterprises Company Ltd.3368 Liquidation, avis de: Société de Bienfaisance St-Jean-Baptiste de Notre-Dame-de-Granby.3398 Syndicat Coopératif de Villemontel.3398 Proclamations: Concernant l'annexion d'un certain territoire au canton Clermont.3401 Concernant l'annexion d'un certain territoire au village de Lawrenceville.3400 Concernant l'érection du village d'Ayers-ville.3399 Sieges sociaux: Chibougamau Explorers Limited.3403 Dominion Asssociated Brands Inc.3403 Rica Biscuits Limitée.3403 Roxbury Chemical Company (Canada) Limited.3402 Téléphone Chibougamau, Limitée \u2014 Chibougamau Telephone, Limited.3403 Berger de Paris Ltée.3355 Canada Door Installers Ltd.3355 Charlotte Limited.3356 Club de Hockey Lachine Rapides.3356 Desroches & Frère Inc.3356 Éditions J.Dupuis, Fils & Cie Inc.3357 .Empire Electric Supply Company (Correction).3397 Fourrures Belmont Inc.3357 Frank A.Patrick Limited.3357 Garage National de St-Georges Incorporée.3358 Hôpital Voghel Inc.3358 J.A.Angel & Son Ltd.3358 Jack Mignault Limitée.3358 Joliette Scrap Iron & Metal Ltd.3359 Kamet Tool & Die Ltd.3359 Laboratoire Bilophen Laboratory Inc.3359 La Filature de l'Isle-Verte, Limitée.3360 La Fonderie Paquette Foundry Inc.3360 Laquerre & Frère Ltée.3361 Le Cercle des Femmes Journalistes Incorporé.3361 Le Service Social de Nicolet.3361 L'Hôtel National Limitée.3362 Maple Holdings Ltd.3362 Matane Construction Limited.3362 Nérée Guérette & Fils Ltée.3363 Nicole Frères Inc.3363 Packers Equipment & Service Limited.3363 Pel-Ba Inc.\".3364 Pharmacie Antonio Vermette Ltée .3364 Roslyn Holdings Ltd.3364 St-Jean, city of.3397 Syndicat Industriel de St-Lin.3365 Teinturerie Dorchester Inc.3365 Trans-America Petroleums Ltd.3365 Ulric Binette & Fils, Inc.3366 Viandes de Choix, Limitée.3366 West End Furniture Co.3367 Yvan Côté Limitée.3367 Zena Trading Inc.3367 Supplementary Letters Patent: Ciment Québec Inc.3368 Clubs \u2014 4-H \u2014 Clubs, Inc.3369 Gaspesia Sulphite Company Ltd.3368 Gould Bros.Ltd.3368 Zenith Enterprises Company Ltd.3368 Winding up Notices: Société de Bienfaisance St-Jean-Baptiste de Notre-Dame-de-Granby.3398 Syndicat Coopératif de Villemontel.3398 Proclamations: Concerning the annexation of a certain territory to the township of Clermont.3401 Concerning the annexation of a certain territory to the village of Lawrenceville.'.3400 Concerning the erection of the village of Ayersville.3399 Head Offices: Chibougamau Explorers Limited.3403 Dominion Associated Brands Inc.3403 Rica Biscuits Limitée.3403 Roxbury Chemical Company (Canada) (Limited.3402 Téléphone Chibougamau Limitée \u2014 Chibougamau Telephone, Limited.3403 3412 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 décembre 1951, Tome 83, N° 60 .s Québec: \u2014 Imprimé par Rédemiti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédemiti Paradis, imprimeur du Roi.King's Printer.Thomas Duhamel Limitée \u2014 Thomas Thomas Duhamel Limitée \u2014 Thomas Duhamel Limited.3402 Duhamel Limited.3402 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Labelle: Labelle : Martin vs Lalibcrté.3404 Martin vs Laliberté.3404 Montmagny: Montmagny: L'Office du Crédit Agricole du Québec The Quebec Farm Credit Bureau vs vs Labrecque.3404 Labrecque.3404 Montréal: Montreal: Perras vs Roy.3406 Perras vs Roy.3406 Rimouski : Rimouski : Le Roi vs Drouin.3407 Le Roi vs Drouin.3407 Le Roi vs Gagnon.3407 Le Roi vs Gagnon.3407 Rouyn-Noranda: Rouyn-Noranda: The Northern Life Assurance Company The Northern Life Assurance Company of Canada vs Bartman.3407 of Canada vs Bartman.3407 31679-o 31679-e "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.