Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 26 (no 17)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1952-04-26, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 84, N° 17 1075 Vol.84, No.17 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Officiai Gazette (pubushed by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 26 avril 1952 AVIS AUX INTÊRESSSÊS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute sen: me versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, April 26th, 1952 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to -the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1076 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni (le notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.31753 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration 8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7« per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document'number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u2014 1-52 Lettres patentes Alain Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de mars 1952, constituant en corporation : Léo-Paul Alain, marchand d'automobiles et propriétaire de garage, Gilles Os-tiguy, vendeur, Roméo Laporte, comptable, tous de la cité de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules-moteurs et exploiter des postes de service et des garages, sous le nom de \"Alain Automobile Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 40,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby district judiciaire de Bedford.Letters Patent Alain Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part lof the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec,' bearing date the fifteenth day of March, 1952, incorporating: Léo-Paul Alain, car dealer and garage owner, Gilles Ostiguy, Salesman, Roméo Laporte, accountant, all of the City of Granby, judicial District of Bedford, for the following purposes: To deal in motor véhicules and operate service stations and garages, under the name of \"Alain Automobile Inc.\", with a capital stock of 840,000 divided into 40,000 common shares of a par value of SI each.The head office of the Company will be at Granby, Judicial District of Bedford. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1077 Daté du bureau du Procureur général, le quin- Dated at the office of the Attorney General zième jour de mars 1952.this fifteenth day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423 .L.DÉSILETS.32423-0 Deputy Attorney General.Albert Lefebvrc Ltée Albert Lefebvrc Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that Part I of the Que-partie de la Loi des compagnies de Québec, il a bec Companies Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Pro-province de Québec, des lettres patentes en date vince of Quebec, bearing date the first day of du premier mars 1952, constituant en corporation: March, 1952, incoporating: Gérard Corbeil, ad-Gérard Corbeil, avocat, de la cité de Longucuil, vocate, of the city of Longueuil, Léo Davignon, Léo Davignon, comptable, de la cité de Mont- accountant, of the City of Montreal, both of the real, tous deux du district judiciaire de Montréal, judicial district of Montreal, Jeanne Drouin, Jeanne Drouin, épouse contractuellcment séparée wife separate as to property by marriage contract de biens de Jean Frechette, secrétaire, de Belœil, of Jean Frechette, secretary, of Belœil, judicial district judiciaire de Richelieu, povir les objets district of Richelieu, for the following purposes: suivants: Faire affaires comme courtier en assurance et To do business as an insurance broker and to agir comme agent d'assurances, sous le nom de act an insurance agent, under the name of \"Albert \"Albert Lefebvrc Ltée\", avec un capital de Lefebvre Ltée\", with a capital stock of 840,000 810,000 divisé en 1,000 actions ordinaires tTune divided into 1,000 common shares of a par value valeur au pair de $10 chacune et en 300 actions of S10 each and into 300 preferred shares of a privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune, par value of S100 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont-district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le pre- Dated at the office of the Attorney General, inier jour de mars 1952.this first day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423-0 L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Andrjesson Manufacturing Co.Andrjesson Manufacturing Co.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the tenth day du dixième jour de mars 1952.constituant en of March, 1952, incorporating: Maurice Langlois corporation: Maurice Langlois, Frank Ivan Rite- Frank Ivan Ritchie, Jr., both advocates, Albert liie, fils tous deux avocats, Albert Langlois, agent Langlois, insurance agent, all of the City and d'assurances, -tous des cité et district judiciaire Judicial District of Trois-Rivières, for the foll- des Trois-Rivières, pour les objets suivants: wing purposes: Manufacturer et faire le commerce de barils, To manufacture and deal in barrels, kegs, caques, emballages, réceptacles sous le mon de packages, containers, under the name of \"Andr- \"Andrjesson Manufacturing Co.\", avec un ca- jesson Manufacturing Co.\", with a capital stock pital de 875,000 divisé en 35.000 actions privilé- of 875,000 divided into 35,000 preferred shares giées de 81 chacune et 40,000 actions ordinaires of 81 each and 40,000 common shares of 81 each, île 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Trois- The head office of the Company will be at Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Trois-Rivières, Judicial District of Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General dixième jour de mars 1952.this tenth day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSDLETS, 32423 L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Arnold Printing Co.Ltd.Arnold Printing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that Part I of the Que-patie de la Loi des compagnies de Québec, il a bec Companies Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Pro-province de Québec, des lettres patentes en date vince of Quebec, bearing date the seventh day du spetième jour de mars 1952, constituant en of March, 1952.incorporating: Mayer Gold-corporation: Mayer Goldhagen, gérant, Erich hagen, manager.Erich Goldhagen, student, both Goldhagen, étudiant, tous deux de la cité de of the City of Montreal, Arnold Lorentz, printer, Montréal, Arnold Lorentz, imprimeur, de la cité of the City of Westmount, all in the Judicial de Westmount, tous du district judiciaire de District of Montreal, for the following purposes: Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs, et éditeurs,.To carry-on the business of printers, publis- sous le nom de \"Arnold Printing Co.Ltd.\", avec\" hers, under the name of \"Arnold Printing Co.\", un capital de 820,000 divisé en 100 actions ordi- with a capital stock of 820,000 divided into 100 naires et 100 actions privilégiées toutes d'une common shares and 100 preferred shares, all of valeur au pair de $100 chacune.the par value of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the Company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté au bureau du Procureur général, le sep- Dated at the office of the Attorney General tième jour de mars 1952.this seventh day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DESDLETS, 32423 L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General. 1078 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 avril 1952, Tome Si, N° 17 Art Novelty Embroidery Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour de février 1952, constituant.en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur 1).Ruby.Lewis J.Manolson, tous deux comptables agréés, Irwin B.Blond, notaire public, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer toutes ou aucune des affaires de brodeurs, manufacturiers et marchands d'habits cl vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Art Novelty Embroidery Limited\", avec un capital de 810.000 divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et 150 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinquième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Association Canadienne de l'Aide aux Réfugiés d'Europe Orientale Canadian Society for the Aid of Eastern European Refugees Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq mars 1952, constituant, en corporation sans capital-actions: B.Bych-licki, comptable, de Ville Mont-Royal, Robert Hill, gérant d'une compagnie d'assurance, Prank G.Cray, surintendant d'une manufacture de bas.Frank Michalak, agent d'assurance, P.Yuskcvicia Miller, instituteur, G.F.Lengvari, agent d'assurance, X.George Zoldners, ingénieur en béton, A.Spurmanis, ingénieur pro-fessionel, tous de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Assister les personnes d'origine est et sud européenne, sous le nom de \"Association Canadienne de l'Aide aux Réfugiés d'Europe Orientale\" \"Canadian Society for the Aid of Eastern European Refugees\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 81,000,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le cinquième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 t.DÉSILETS.Association des Hommes d'Affaires de Ville St.Pierre Inc.Avis est donné qu'en vertu (les dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1952, constituant en corporation sans capital-actions Joseph Wilfrid Brasseur, marchand-quincaillier, Ernest Hamel, marchand-plombier, Gordon Marriott, marchand-distributeur, Rodolphe Aubry, mar-chand-retaurateur, Maurice Gauron, marchand-mercier, tous de Ville St-Pierre, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Promouvoir et favoriser les intérêts économiques, sociaux, civiques et sportifs des hommes Art Novelty Embroidery Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of February, 1952, incorporating: Mil-ton Lowcn Klein, advocate, Arthur D.Ruby, Lewis J.Manolson, both chartered accountants, Irwin B.Blond, notary public, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on all or any of the business of embroiderers, manufacturers and dealers in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Art Novelty Embroidery Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 250 common shares of 8100 each and 150 preferred shares of 8100 each.The head oflice of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General this twenty-fifth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Association Canadienne de l'Aide aux Réfugiés d'Europe Orientale Canadian Society for the Aid of Eastern European Refugees Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: B.Bychlicki, accountant, of the Town of Moint-Royal, Robert Hill manager of an insurance company, Frank G.Gray, superintendant of a stocking factory, Frank Michalak.P.Yuskcvicia Miller, teacher, G.F.Lengvari insurance agent, N.George Zoldners, concrete engineer, A.Spurmanis, professional engineer, all of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To assist Eastern and Southern Europeans, under the name of \"Association Canadienne de l'Aide aux Réfugiés d'Europe Orientale\"\u2014 \"Canadian Society for the Aid of Eastern European Refugees\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is 81,000,000.The head oflice of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Association des Homines d'Affaires de Ville St.Pierre Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital Joseph Wilfrid Brasseur, hardware merchant, Ernest Hamel.merchant-plumber, Gordon Marriott, dealer-distributor, Rodolphe Aubry, merchant-restaurant-keeper, Maurice Gagnon, haberdasherry-merchant, all of the town of St-Pierre, judicial district of Montreal, for the following purposes To promote and favor the economic, social, civic and sporting interests of the business men QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol 8/\u201e No.17 1079 I d'affaires de Ville St-Pierre, sous le nom de \"Asso-I eiation des Hommes d'affaires de Ville St-Pierre Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est j de S99.000.Le siège social de la coqwration sera à Ville | St-Pierre, district judiciaire de Montréal.| Daté du bureau du Procureur général le sixiè- L me jour de mars 1952.\\ L'Assistant-procureur général.I 32423 L.DÉSILETS.Avalon Hosiery Limited I Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la II province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour de mars 1952, constituant en ¦; corporation Milton Lowcn Klein, avocat, Ar- thur D.Ruby, comptable agréé, Lewis J.Manol-son, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de vêtements et articles vestimentaires, sous le nom de \"Avalon Hosiery Limited\", avec un capital de 8200,000 divisé en 1200 actions ordinaires de 8100 chacune et S00 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le qua-! trième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Bcaupar Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de février 1952, constituant en corporation: Philip Fischel, Vineberg, avocat, de la cité de Westmount, Jack Lighstone, avocat, Yvonne Bélanger, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un magasin pour faire le commerce de vêtements, produits textiles, quincaillerie, meubles, appareils de maison, produits, dispositifs et installations électriques et de télévision, sous le nom de \"Bcaupar Company\", avec un capital de 810,000 divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huitième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.of the Town of St-Picrre, under the name of \"Association des Hommes d'Affaires de Ville St-Pierre Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is 899,000.The head office of the corporation will be in the town of St-Pierre, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Avalon Hosiery Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lientenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of March, 1952, incorporating Mill on Lowcn Klein advocate, Arthur D.Ruby, chartered accountant, Lewis J.Manolson, chartered accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes To carry on the business of manufacturers and dealers in clothing and wearing apparel, under the name of \"Avalon Hosiery Limited\" with a capital stock of 8200,000 divided into 1200 common shares of 8100 each and 800 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial District of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General this fourth day of March, 1952.L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Beaupar Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of February, 1952, incorporating: Philip Fischel Vineberg, advocate, of the City of Westmount Jack Lighstone, advocate, Yvonne Bélanger, secretary, both of the City of Montreal, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate a store dealing in wearing apparel, textiles,, hardware, furniture, household appliances, electrical and television products, appliances and equipment, under the name of ''Beaupar Company\", with a capital stock of 810,000 divided into 1.000 shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentv-cighth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Bédard & Donalson Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorze mars 1952, constituant en corporation: René Bédard.confiseur, Raoul Donaldson, apprenti-confiseur, Victor Paquet, commerçant, tous trois des cité et district judiciaire de Québec: Albert Paquet, comptable, des cité et district Bédard & Donalson Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of March, 1952, incorporating: René Bédard, confectioner, Raoul Donaldson, apprentice-confectioner, Victor Paquet, dealer, all three of the city and judicial district of Quebec, Albert Paquet, accountant, of the city and judicial dis- 1080 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 judiciaire de Montréal, pour les objets suivants, Exploiter l'industrie et le commerce de confiserie, sous le nom de \"Bédard & Donaldson Limitée\", avec un capital de 840,000 divisé en 1500 actions ordinaires de S10 chacune, et 250 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le quatorzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Boilv & Cie, Ltée Boily & Co, Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze mars 1952, constituant en corporation: Leopold Boily, commerçant, Laurctte Tremblay, épouse de Lé'pold Boily, Louis Emile Hudon, comptable, tous de St-Joseph d'Ahna, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Faire le commerce de ferronnerie, matériaux de construction, d'appareils et accessoirs de chauffage, d'électricité, de plomberie, et de réfrigération, agir comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Boily & Cie, Ltée\" \u2014 \"Boily & Co, Ltd\", avec1 un capital de 820,000 divisé'en 2,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Joseph d'Alma, district judiciaire de Roverval.Daté du bureau du Procureur général le douzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Bowman Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 27(5, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-sept mars 1952, constituant en corporation: Jean-Paul Héroux, commerçant, Claire Déry-Héroux, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, Léo Bowman, constructeur, Marcelle Déry-Bowman, secrétaire, tous deux de la cite d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agent d'immeubles, sous le nom de \"Bowman Corporation Limited\", avec un capital-actions de 840,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-septième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.trict of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and industry of confectioner, under the name of \"Bédard & Donaldson Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 1500 common shares of $10 each, and 250 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Boily & Cie, Ltée Boily & Co, Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of March, 1952, incorporating: Leopold Boily, trader, Laurctte Tremblay, wife of Leopold Boily, Louis Emile Hudon, accountant, all of St-Joseph d'Ahna, judicial district of Roberval, for the following purposes: To deal in ironware, building materials, heating, electricity, plumbing and refrigeration apparatus and accessories, act as general building contractors, under the name of \"Boily & Cie, Ltée\" \u2014 \"Boily & Co, Ltd.\" with a capital stock of 820,000, divided into 2,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at St-Joseph d'Alma, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Bowman Corporation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of March, 1952, incorporating: Jean-Paul Héroux, dealer, Claire Déry-Héroux, secretary, both of the city of Montréal.Léo Bowman, builder, Marcelle Déry-Bowman, secretary, both of the city of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate agent, under the name of \"Bowman Coiporation Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 1,000 common shares of 810 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Breuvages Sept-Iles Ltée Seven Islands Beverages Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1952, constituant en corporation Gustave Blouin, Pierre Roy, tous deux Breuvages Sept-Iles Liée Seven Islands Beverages Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of February, 1952, incorporating Gustave Blouin, Pierre Roy, both dealers of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.S/,, No.17 1081 commerçants, de la ville de Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay, Maurice 'fessier, avocat, de la ville de Rimouski, district judiciaire de Ri-mouski, pour les objets suivants Faire la fabrication, la vente d'eau gazeuse et de crème glacée, confiseries et épicerie, sous le nom de \"Breuvages Sept-Iles Ltée\"\u2014\"Seven Island Beverages Ltd\", avec un capital de $50,-000 divisé en 250 action ordinaires de 8100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera dans la ville de Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deuxième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Canadian Foods Exhibit Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mars 1952, constituant en corporation René Lemay, industriel, Marcel Desparois, comptable, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, Elphège Guyon, gérant, de St-Pie, district judiciaire de St-Hyacinthe, pour les objets suivants Organiser et promouvoir des expositions de produits alimentaires et autres, sous le nom de \"Canadian Foods Exhibit Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions ordin-naires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le troisième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Canadian Rod & Gun Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du troisième jour de mars 1952, constitutant en corporation: Asher Levine, marchand, de la cité d'Outremont, Joshua Levine, marchand, Ida Morris, ménagère, épouse séparée de biens dudit Joshua Levine, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises de sports, ferronnerie, accessoires et outillages électriques, sous le nom de \"Canadian Rod & Gun Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le troisième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Carrière Pointe-Claire Inc.Pointe-Claire Quarry Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quatorze mars 1952, constituant en corporation: town of Sept-Iles, judicial district of Saguenay, Maurice 'fessier, advocate, of the town of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes To fabricate, to sell aerated waters and icecream, confectionery and groceries, under the name of \"Breuvages Sept-Iles Ltée\"\u2014\"Seven Islands Beverages Ltd\", with a capital stock of $50,000 divided into 250 common shares of 8100 each and into 250 preferred shares of SlpO each.The head office of the company will be in the town of Scpt-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, ] 952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Canadian Foods Exhibit Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1952, incorporating René Lemay, industrialist, Marcel Desparois, accountant, both of the city and judicial district of Montreal, Elphège Guyon, manager, of St-Pie, judicial district of St-Hyacinthe, for the following purposes To organize and promote exhibitions of foodstuffs and other products, under the name of \"Canadian Food Exhibit Inc.\", with a capital stock of 810,000 divided into 100 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Canadian Rod & Gun Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1952, incorporating: Asher Levine, merchant, of the City of Outremont, Joshua Levine, merchant, Ida Morris, housewife, wife separate as to property of the said Joshua Levine, both of the City of Montreal, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sporting goods, hardware, electrical supplies and products, under the name of \"Canadian Rod & Gun Co.Ltd.\", with a capital stock of 840,000 divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of March, 1952.L.DÉSILETS.32423-0 Deputy Attorney General.Carrière Pointe-Claire Inc.Pointe-Claire Quarry Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of March, 1952, incorporating: Edmond 1082 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 8/,, N° 17 Edmond Meloche, bourgeois.Rosaire Mcloche, Marcel Meloche, Antonin Mcloche, tous trois journaliers, tous de Beaconsficld, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une carrière et vendre de la pierre de taille et des monuments et autres objets artistiques, sous le nom de \"Carrière Pointe-Claire Inc.\" \u2014 \"Pointe-Claire Quarry Inc.\", avec un capital de 8100,000 divisé en 500 actions ordinaires de 8100 chacune et 500 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 235 Montée St-Michel, Beaconsficld, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Clarke Funeral Home Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de mars 1952, constituant en corporation William* James McQuillan, George Norman Brodcrick, tous deux avocats, Elsie Chappell, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Exercer le commerce de directeurs funéraires, sous le nom de \"Clarke Funeral Home Inc.\", avec un capital de 8100,000 divisé en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 55S0 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Colonial Pulp & Paper Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de février 1952, constituant en corporation Maurice Mercier, avocat, Gretta Wainwright, Louise Héon, sténographes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Faire le commerce et manufacturer du bois de pulpe, papier de pulpe et produits du papier de pulpe, bois de charpente, bois de construction, bois et articles en papier de toute nature et sorte, sous le nom de \"Colonial Pulp & Paper Company Limited\", avec un capital de 840,000 divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huitième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Meloche, bourgeois, Rosaire Meloche, Marcel Meloche, Antonin Meloche, all three labourers, all of Beaconsficld, judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate a quarry and sell cut stone and monuments, and other artistic objets, under the name of \"Carrière Pointe-Claire Inc.\" \u2014 \"Pointe-Claire Quarry Inc.\", with a capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of S100 each, and 500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 235 Montée St-Michel, Beaconsficld, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32123 Deputy Attorney General.Clarke Funeral Home Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March, 1952, incorporating William James McQuillan, George Norman Broderick, both advocates, Elsie Chappell, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following puiposcs To carry on the business of funeral directors, under the name of \"Clarke Funeral Home Inc.\", with a capital stock of $100,000 divided into 500 preferred shares of the par value of 8100 each and 500 common shares of the par value of 8100 each.s The head office of the Company will be at 5580 Sherbrooke St.West, Montreal, Judicial restrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Colonial Pulp & Paper Company Limited* Notice is hereby given that under Part I o the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of February, 1952, incorporating Maurice Mercier, advocate Gretta Wainwright, Louise Héon, stenographers, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes To deal in and manufacture pulp wood, pulp paper and pulp paper product, timber, lumber, wood and paper goods of every nature and kind, under the name of \"Colonial Pulp & Paper Company Limited'.', with a capital stock of 840,000 divided into 5,000 common shares of a par value of 81 each, and 350 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Construction Mont Royal Limitée Construction Mont Royal Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Moris- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8J\u201e No.17 1083 set, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorze mars 1952, constituant en corporation: Valère Lecrcnier, entrepreneur, de St-Vincent de Paul, Jacques Raymond, entrepreneur, J.-Téles-phore Raymond, comptable agréé, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie de constructions, sous le nom de \"Construction Mont Royal Limitée\", avec un capital de 810,000 divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1414 Crescent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorzième jour de mars 1952.L'ÀSsistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Desaulniers & Fils Liée Desaulniers & Sons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-et-un février 1952, constituant en corporation: Alfred Tourigny, c.r., avocat, d'Outrcmont, Rita Dufresne, Lucienne Mérineau, secrétaires, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire de la construction, sous le nom de \"Desaulniers & Fils Ltée\" - \"Desaulniers & Sons Ltd.\", avec un capital de 850,000 divisé en 24 actions communes de $100 chacune.96 actions pri-viligiées de $100 chacune de la série \"a\", 380 actions privilégiées de 8100 chacune série \"b\".Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-et-unième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DESILETS.Duehesnc Auto Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du onze mars 1952, constituant en corporation Jean-Marie Duchesne, marchand.Gérard Duehesnc, gérant de service, Germaine Boivin, épouse séparée de biens de Jean-Charles Duchesne et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants Faire le commerce de véhicules-automobiles, et faire l'exploitation d'ateliers mécaniques, de boutiques de réparations et de garages, sous le nom de \"Duchesne Auto Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera Naud-ville, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le onzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Electro Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été set, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of March, 1952, incorporating: Valère Lecrenier, contractor, of St-Vincent de Paul, Jacques Raymond, contractor, J.Télesphore Raymond, chartered accountant, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the construction business and industry, under the name of \"Construction Mont Royal Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 1414 Crescent, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Desaulniers & Fils Ltée Desaulniers & Sons Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of February, 1952.incorporating: Alfred Tourigny, Q.C., advocate, of Outremont, Rita Dufresne, Lucienne Mérineau, secretaries, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To undertake construction work, under the name of \"Desaulniers & Fils Ltée\" \u2014 \"Desaulniers & Sons Ltd.\", with a capital stock of $50,000 divided into 24 common shares of $100 each, 96 Class \"A\" shares of $100 each and 380 Class \"B\" preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-first day of February, 1952.L.DÉSILETS.324215 Deputy Attorney General.Duchesne Auto Limitée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of March, 1952, incorporating Jean Marie Duchesne, merchant, Gérard Duchesne, service manager, Germaine Boivin, wife separate as to property of Jean Charles Duchesne and duly authorized by him for the purposes hereof, all of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes To deal in motor vehicles, and operate machine shops, repair shops and garages, under the name of \"Duchesne Auto Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Naudville, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Electro Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have 1084 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour de février 1952, constituant en corporation Joseph Shapiro, avocat et Conseil en Loi du Roi, Joseph R.Hoffman, Boris Gar-maise, tous deux avocats, tous des cités et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Electro Corp.\" Le capital de la compagnie est divisé en 3,000 actions sans valeur nominale ou au pair et en 1,000 actions privilégiées de S100 chacune et le montant avec le quel la compagnie commencera ses opérations ne sera pas moindre de 825,000.if ^ Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de féviier 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Empire Machine Works Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit mars 1952, constituant en corporation: Joseph Alexandre Tremblay, courtier, Gactane Richer, Françoise Bellay, sténographes, tous trois des cité et district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Manufacturer réparer, acheter, vendre des bouilloires, engins, machineries, outils et toutes sortes d'articles en fer, cuivje, coppe, acier ou autres métaux, sous le nom de \"Empire Machine \"Works Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1087 rue Plcssis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Ferronnerie Belmont Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huitième jour de mars 1952, constituant en corporation: Richard Crépeau, Léonce Côté, tous deux avocats, Corinne P.Sirois, veuve non remariée de Horace Sirois, Laurent Dumont, notaire, tous quatre de Sherbrooke, Robert Mailhot, représentant d'affaires, de Rock- Forest, tous du district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de ferronnerie et manufacturiers, sous le nom de \"Ferronnerie Belmont Limitée\", avec un capital de 875,000 divisé en 5,000 actions privilégiée de S10 chacune et 2,500 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 2423 L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, repiesented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of February 1952, incorporating Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Joseph R.Hoffman, Boris Garmaise, both advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes To carry on the business of a real estate and investment corporation, under the name of \"Electro Corp.\" The capital stock of the company is divided into 3,000 shares having no nominal or par value, and into 1,000 preferred shares of 8100 each, and the amount with which the company will commence its operations will be not less than 825,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-o Deputy Attorney General.Empire Machine Works Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1952, incorporating: Joseph Alexandre Tremblay, broker, Gactane Richer, Françoise Bellay, stenographers, all three of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, repair, purchase, sell boilers, engines, machinery, tools and all kinds of articles made of iron, copper, \"coppe\", steel or other metals, under the name of \"Empire Machine Works Ltd\", with a capital stock of S40.000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1087 Plessis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Ferronnerie Belmont Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1952, incorporating: Richard Crépeau, Léonce Côté, both lawyers, Corinne P.Sirois, unmarried widow of Horace Sirois, Laurent Dumont, notary, all four of Sherbrooke, Robert Mailhot, business representative, of Rock-Forest, all in the Judicial District of St.Francis, for the following purposes: To carry on the businesses of hardware merchants and manufacturers, under the name of \"Ferronnerie Belmont Limitée\", with a capital stock of $75,000 divided into 5,000 preferred shares of $10 each and 2,5000 common shares of $10 each.The head office of the Company will be at Sherbrooke, Judicial District of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol 84, No.17 1085 Ferronnerie Rouleau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2r chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-six février 1952, constituant en corporation Henri-Paul Rouleau, commerçant, de Sillery, Pierre Côté, Taschcreau Fortier, avocats, tous deux de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants Exercer le commerce de quincaillier, agir comme constructeur, sous le nom de \"Ferronnerie Rouleau Ltée\", avec un capital de S40,000 divisé en 40,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sillery, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Fregeau & Lussicr Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1952, constituant en corporation Jean-Maurice Frégeau, contremaître, du village de Rougemont, Jean-Robert Lussier, contremaître, de la cité de St-Hyacinthe, tous deux du district judiciaire de St-Hyacinthe, Georges-Henri Dureault, c.r., avocat, Rita Nantcl, secrétaire, tous deux de la cité de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants Exercer l'industrie, le commerce et les opérations d'entrepreneurs et constructeurs, sous le nom de \"Fregeau & Lussier Inc.\", avec un capital de 340,000 divisé en 340 actions privilégiées de 8100 chacune, et 60 actions communes de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Ferronnerie Rouleau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 272, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating Henri-Paul Rouleau, dealer, of Sillery, Pierre Côté, Tasche-reau Forticr, advocates, both of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes To carry on the business of hardware dealer and act as builder under the name of \"Ferronnerie Rouleau Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of February, 1952.L.DESILETS, 32423 Deputy Attorney General.Fregeau & Lussier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1952, incorporating Jean-Maurice Fregeau, foreman, of the village of Rougemont, Jean-Robert Lussier, foreman, of the city of St-Hyacinthe, both of the judicial district of St-Hyacinthe, Georges-Henri Dureault, Q.C., advocate, Rita Nantel, secretary, both of the city of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes To carry on the industry, the business and the operations of contractors and builders, under the name of \"Fregeau & Lussicr, Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 340 preferred shares of $100 each, and 60 common shares of $100 each.The head office of the company will be in the city of Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Gencux Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de février 1952, constituant en corporation: Norman Genser, Sydney Phillips, avocats et Tessy Frankel, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de garage public d'automobiles, sous le nom de \"Genoux Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huitième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Geneux Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of February, 1952, incorporating: Norman Genser, Sydney Phillips, advocates, Tessy Frankel, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate a public automobile garage business, under the name of \"Geneux Ltd,\", with a capital stock of $40,000 divided into 1,000 common shares having a par value of 81 each and 390 preferred shares having a par value of S100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General. 10S6 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 George A.Watson (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sixième jour de février 1952, constituant en corporation: Doroty Patman, épouse séparée de biens de Valentine Patman, Madeline Tubb, Gwendoline Christine Teale, épouse séparée de biens de Francis Roland Teale, toutes secrétaires de la cité de Toronto, province d'Ontario, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le négoce de toutes sortes de textiles, produits textiles, vêtements tricotés et sous-produits de toutes sortes, sous le nom de \"George A.Watson (Quebec) Limited\", avec un capital de 8100.000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1449 rue St-Alcxandre, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Glen Villa Estates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de mars 1952, constituant en corporation Wesley Hyndman Bradley, avocat et conseil en loi de la Reine, Douglas Stevens Howard, avocat, Jeannette Hugo, sténographe, tous de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants Transiger les affaires d'une compagnie de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Glcn Villa Estates Ltd.\" Le capital-actions de la compagnie est divisé en 2,000 actions catégorie \"A\" sans valeur nominale ou au pair et en 6,000 actions catégorie \"B\" sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations ne sera pas moins que S40.000.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Sherbrooke, district judiciaire de St-François.^ Daté du bureau du Procureur général, le huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.George A.Watson (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating: Dorothy Patman, wife sepcrate as to property of Valentine Patman, Madeline Tubb, Gwendoline Christine Teale, wife sepcrate as to property of Francis Roland Teale, all secretaries, of the City of Toronto, Province of Ontario, for the following purposes: To manufacture and deal in or with all kinds of textiles, textile products, knitwear, and byproducts of all kinds, under the name of \"George A.Watson (Quebec) Limited\", with a capital stock of 8100,000 divided into 100 common shares having a par value of S100 each and 900 preference shares having a par value of S100 each.The head office of the Company will be at 1449 St.Alexander Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentv-sixth dav of February.1952.L.DESILETS, 32423-o Deputy Attorney General.Glen Villa Estates Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the L ieutcnant-Govemor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1952, incorporating 'Wesley Hyndman Bradley, advocate and Queen's Counsel, Douglas Stevens Howard, advocate.Jeannette Hugo, stenographer, all of the city of Sherbrooke, in the judicial district of St.Francis, for the following purposes To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"Glcn Villa Estates Ltd.\" The capital stock of the company is divided into 2,000 Class \"A\" shares without nominal or par value and 6,000 ('lass \"B\" shares without nominal or par value, and the amount of capital stock with which tho company will commence its operations will not be less than 840,000.The head office of the company will be at the city of Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Hcrshaw Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour de février 1952, constituant en corporation Joseph Shapiro, avocat et Conseil en Loi du Roi, Joseph R.Hoffman, Boris Garmaisc.tous deux avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Her-shaw Corp.\" Le capital de la compagnie est divisé en 2,000 actions sans valeur nominale ou pair et en 850 actions de $100 chacune et le montant avec lequel Hcrshaw Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of February, 1952, incorporating Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Joseph R.Hoffman, Boris Garmaisc, both advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes To carry on the business of a real estate and investment corporation, under the name of \"Her-shaw Corp.\" The capital stock of the company is divided into 2,000 shares having no nominal or par value, and into 850 shares of 8100 each, and the amount QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1087 a compagnie commencera ses opérations ne sera pas moindre de 318,500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Hôpital St-Louis de Windsor, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix mars 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Dominique Lambert, médecin, Paul-Aimé de Bellefcuille, dessinateur, Jean de Bellefcuille, machiniste, tous de Québec, district judiciaire de Quçbcc, pour les objets suivants: Etablir et administrer un hôpital privé, sous le nom de \"Hôpital St-Louis de Windsor, Inc.\" Le siège social de la corporation sera à 23 rue Dearden, Windsor, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général le dixième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Imprimerie Laurent ieniie Limitée Laurantian Printing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mars 1952, constituant en croporation: Jean-Louis Livernoche, marchand, de l'Epiphanie, Gaston Pelland, garagiste, Marcel Hamel, journaliste, tous deux de l'Assomption, tous du district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'imprimerie, sous le nom de \"Imprimerie Lauientienne Limitée\" \u2014 \"Laurentian Printing Limited\", avec un capital de S40,000 divisé en 400 actions de $50 chacune, et en 400 actions privilégiées d'une valeur nominale de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à L'Assomption, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général le troisième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Janpcr Construction Ltd.Avis est donné qu'en, vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de février 1952, constituant en corporation Philippe Fishel Jack Lightstone, David Goodman, tous deux avocats, Imelda Langlois, tous trois de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Exercer le commerce d'entrepreneurs et constructeurs, sous le nom de \"Janper Construction Ltd.\", avec un capital de $100,000 divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.with which the company will commence its operations will be not less than $18,500.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth dav of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Hôpital St-Louis dc Windsor, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Dominique Lambert, physician, Paul-Aimé de Bellefcuille, draftsman.Jean de Bellefcuille, machinist, all of Quebec, judicial district of Quebec, for the following purposes: To establish and .manage a private hospital, under the name of \"Hôpital St-Louis de Windsor, Inc.\" The head office of the corporation will be at 23 Dearden Street, Windsor, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Imprimerie Laurcnlienne Limitée Laurantian Printing Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1952, incorporating: Jean-Louis Livernoche, merchant, of l'Epiphanie, Gaston Pellan, garage-keeper, Marcel Hamel, journalist, both of l'Assomption, all of the judicial district of Joliette, for the following purposes: To engage in the printing business, under the name of \"Imprimerie Laurcntienne Limitée\" \u2014 \"Laurantian Printing Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $50 each, and into 400 preferred of a nominal value of $50 each.The head office of the company will be at l'Assomption, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of March, 1952.L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Janper Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March, 1952, incorporating Philip Fischel Vineberg, advocate, of Westmount, Jack Light-stone David Goodman, both advocate, Imelda Langlois, all three of Montreal, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes To carry on business as contractors and builders, under the name of \"Janper Construction Ltd.\", with a capital stock of $100,000 divided into 5,000 common shares of the par value of $10 each, and 5,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal. 108S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 86 avril 1952, Tome 84, N° 17 Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Jeune Commerce Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six février 1952, constituant en corporation Louis Dussault, avocat, de Sillery, Alfred Levesque, gérant, de Québec, tous deux du district judiciaire de Quebec, Oswald Parent, comptable agréé, de Hull, district judiciaire de Hull, Paul-Henri Lavoic, gérant, de Ste-Rose, Jean-Paul Grégoire, avocat, André Gagnon, comptable, Fernand Drapeau, industriel, de Montréal, tous quatre du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Faire affaires comme propriétaire de journaux et éditeurs, sous le nom de \"Jeune Commerce Inc.\", avec un capital de 820,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureu r général, 32423-o L.DÉSILETS.J.L.De Quoy & Cie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorze mars 1952, constituant en corporation: Bernard Nantel, Gilles Leblanc, avocats, Jacqueline Gougeon, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous les appareils de chauffage, sous le nom de \"J.L.De Quoy & Cie Limitée\", avec un capital de 819,900 divisé en 199 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.J.N.Bolduc, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province-de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf février 1952, constituant en corporation: Louis-Philippe Gagnon, Paul L'Heureux, avocats, Auréa Bolduc, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'appareils de chauffage, sous le nom de \"J.N.Bolduc, Limitée\", avec un capital de 875,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de 825 chacune et 1,000 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuvième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney Genera).Jeune Commerce Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating Louis Dussault, advocate, of Sillery, Alfred Levesque, manager of Quebec, both of the judicial district of Quebec, Oswald Parent, chartered accountant of Hull, judicial district of Hull, Paul-Henri Lavoic, manager, of Ste-Rose, Jean-Paul Grégoire, advocate, André Gagnon, accountant, Fernand Drapeau, industrialist, of Montreal, all four of the judicial district of Montreal, for the following purposes To carry on business as proprietors of newspapers and editors under the name of \"Jeune Commerce Inc.\", with a capital slock of $20,000 divided into 200 common shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General this twenty-sixth dav of February.1952.L.DESILETS, 32423 Deputy Attorney General.J.L.De Quoy & Cie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of March, 1952, incorporating: Bernard Nantel, Gilles Leblanc, advocates, Jacqueline Gougeon, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in heating apparatus, under the name of \"J.L.De Quoy & Cie Limitée\", with a capital stock of S19.900 divided into 199 shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.J.N.Bolduc, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of February, 1952, incorporating: Louis Philippe Gagnon, Paul L'Heureux, advocates, Auréa Bolduc, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in heating systems, under the name of \"J.N.Bolduc, Limitée\", with a capital stock of $75,000 divided into 1,000 common shares of $25 each and 1,000 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of February, 1952.L.DESILETS, 32423 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol 81, No.17 1089 J.P.Plastering Co.Ltd.J.P.Plastering Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouvernem de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, des lettres patentes en date du Province of Quebec, bearing date the twentieth vingt février 1952, constituant en corporation day of February, 1952, incorporating Yvon Y von Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau, secré- Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau, secretary, taire, Rita Dufresne, secrétaire, tous des cité et Rita Dufresne, secretary, all of the city and judi-district judiciaire de Montréal, pour les objets cial district of Montreal, for the following pursuivants poses Exercer l'industrie d'entrepreneurs et de cons- To carry on the business of contractors and tructeurs de travaux publics et privés, sous le builders for publics and private works, under the nom de \"J.P.Plastering Co.Ltd.\", avec un name of \"J.P.Plastering Co.Ltd.\", with a capital de $40,000 divisé en 400 actions communes capital stock of $40,000 divided into 400 common de $10 chacune et 360 actions privilégiées de shares of $10 each and 360 preferred shares of $100 chacune.$100 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le Dated at the office of the Attorne}' General, vingtième jour de février 1952.this twentieth day of February, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423-0 L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Kcnmac Chibougamau Mines Limited Kenmac Chibougamau Mines Limited (Libre de responsabilité personnelle) (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispostions Notice is hereby given that under the provide la Loi des compagnies minières de Québec, il a sions of the Quebec Mining Companies Act, été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la letters patent have been issued by the Lieute-province de Québec, des lettres patentes en date nant-Governor of the Province of Quebec, bearing du huitième jour de mars 1952, constituant en date the eight day of March, 1952, incorporating corporation Raymond Lebœuf, Gisèle Behoca- Raymond Lebœuf, Gisèle Behocaray, Liliane ray, Liliane Cloutier, secrétaires, tous des cité et Cloutier, secretaries, all of the City and Judicial district judiciaire de Montréal, pour le objets District of Montreal, for the following purposes suivants Faire des explorations et des recherches pour Prospect and explore for mines and minerais, découvrir des mines et des minerais, sous le nom under the name of \"Kenmac Chibougamau de \"Kenmac Chibougamau Mines Limited\" Mines Limited\" (No Personal Liability), with a (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital stock of $4,000,000 divided into 4,000,000 capital de $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions shares of $1 each par value, de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront The shareholders shall incur no personal aucune responsabilité personnelle au-delà du responsability in excess of the amount of the montant du prix payé ou convenu d'être payé price paid or agreed to be paid to the company à la compagnie pour ses actions.for its shares.Le siège social de la compagnie sera à 266 ouest, The head office of the Company will be at rue St.-Jacques, chambre 412, Montréal, district 266 St.James St.West, Room 412, Montreal, judiciaire de Montréal.Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General huitième jour de mars 1952.this eight day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.32423 L.DÉSILETS.32423-0 Deputy Attorney General.Knopp's Coiffure Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date «lu quatorzième jour de mars 1952, constituant en corporation: Matteo Santateresa, coiffeur, Muriel Belcher, Santateresa, marchande publique, épouse séparée de biens de Matteo Santateresa, Antonio Albione, entrepreneur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants.Exercer le commerce de coiffeurs, barbiers, ma-nicuristes et masseurs, sous le nom de \"Knopp's Coiffure Co.\", avec un capital de $30,000 divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Knopp's Coiffure Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of March, 1952, incorporating: Matteo Santateresa, hairdresser, Muriel Belcher Santateresa marchande publique, wife separate as to property of Matteo Santateresa, Antonio Albione, contractor, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hairdressers, barbers, manicurists, and massage, under the name of \"Knopp's Coiffure Co.\", with a capital stock of $30,000 divided into 150 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal. 1090 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1962, Tome 84, N° 17 Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.La Compagnie de Prospection de Québec Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit février 1952, constituant en corporation: Eugène Caraghiaur, ingénieur-minier, Aurore Cabba, ménagère, épouse contractuelle-mcnt séparée de biens de Eugène Caraghiaur, Maurice Mercure, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire la prospection générale sur tout terrain ou immeuble minier, sous le nom de \"La Compagnie de Prospection de Québec Incorporée\", avec un capital de §10,000 divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2742 rue Masson, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huitième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.La Compagnie de Publications de Québec Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-cinq février 1952, constituant en corporation Charles-Emile Boily, étudiant en droit, Jean Landry, artiste peintre, Marcelle Boily, employé de bureau tous de Montmorency, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants Exercer les opérations d'imprimeurs, éditeurs, libraires, agents de publicité, sous le nom de \"La Compagnie de Publications de Québec\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Louis de Courville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinquième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.La Compagnie de Prospection de Québec Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of February, 1952, incorporating: Eugène Caraghiaur, mining engineer.Aurore Cabba, housewife, wife separate as to property by marriage contract of Eugène Caraghiaur.Maurice Mercure, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in general prospecting on any mining land or immovable, under the name of \"La Compagnie de Prospection de Québec Incorporée\", with a capital stock of $10,000 divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 2742 Masson street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twcntv-eighth dav of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.La Compagnie de Publications de Québec-Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, H.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of February, 1952, incorporating Charles-Emile Boily, law student, Jean Landry artist, Marcelle Boily, office employees, all of Montmorency, judicial district of Quebec, for the following purposes To carry on business as printers, editors, stationers, publicity agents, under the name of \"La Compagnie de Publications de Québec\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at St-Louis de Courville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.La Compagnie Tulipe Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq mars 1952, constituant en corporation Napoléon Latulippe, manufacturier, de Ville St-Laurent, Jacques Lessard, avocat, de Verdun, Emile Poissant, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Manufacturer et faire le commerce des marchandises sèches, habits et vêtements, sous le nom de \"La Compagnie Tulipe Limitée\", avec un capital de $90,000 divisé en 900 actions de $100 chacune.La Compagnie Tulipe Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of March, 1952, incorporating Napoléon Latulippe, manufacturer, of Ville St-Laurent, Jacques Lessard, advocate, of Verdun, Emile Poissant, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes.To manufacturer and deal in drygoods, clothing and wearing-apparel, under the name of \"La Compagnie Tulipe Limitée\", with a capital stock of $90,000 divided into 900 shares of $100 each.\u2022 \u2022 \u2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2Gth, 1952, Vol.84, No.17 1091 Le siège social de la compagnie sera à Montreal, The head 'office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le cin- Dated at the office of the Attorney General, quième jour de mars 1952.this fifth day of March, 1952.' L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423-0 L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.La ligue des Propriétaires '\u2022St-Joseph\" Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf février 1952, constituant en corporation saus captial-actions: Ernest Aussant, contremaître, Lucien Villiard, voyageur, Georges Hébert ouvrier, Joseph A.Aucoin, rentier, H.Desalliers, gérant de la Caisse populaire, Germain Parenteau, commerçant, Georges Mil-lette, épicier, Lucien Pelletier, ouvrier, Fernand l.atour, commis, tous de St-Joseph de Sorel, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Suivre les intérêts des propriétaires clans les administrations municipales et scolaires, sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires \"St-Joseph\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à St-.loseph de Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuvième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.La ligue des Propriétaires \"St-Joseph\" Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Comapnies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth clay of February, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Ernest Aussant, foreman, Lucien Villiard, traveler, Georges Hébert, workman, Joseph A.Aucoin, pensionner H.Desalliers, manager of the \"Caisse Populaire (('redit Union), Germain Parenteau, dealer, Georges Millette, grocer, Lucien Pelletier, workman, Fernand Latour, clerk, all of St-Joseph of Sorel, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To take the interests of proprietors in the municipal and school administrations, under the name of \"La Ligue des Propriétaires \"St-Joseph\".The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation will be at Saint-Joseph de Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney-General, this twenty-ninth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.La Société Saint-Jean-Baptiste d'Arvida La Société Saint-Jean-Raptiste d'Arvida Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du treize mars 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Jérôme Gauthier, comptable, Louis-Henri TremLliy, J.-René Rioux tous deux commis, tous d'Arvida, district judiciaire de Chicoutmii, pour les objets suivants: Développer chez les canadiens-français un vrai sentiment patriotique, national, culturel, social, religieux et artistique, sous le nom de \"La Société Saint-Jean-Baptiste d'Arvida\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Arvida, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le treizième jour de mars 1952.L'Asssitant-procuruer général, 32423-0 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part ni of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Jérôme Gauthier, accountant, Louis-Henri Tremblay, J.René Rioux, both clerks, all of Arvida, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To promote amongst French-Canadians a true patriotic, national, cultural, social, religious and artistic spririt, under the name of \"La Société Saint-Jean-Baptistc d'Arvida\".The amount to which the immovable property which the corporation mav hold is to be limitée!, is $25,000.The head office of the corporation will be at Arvida, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.L'Association des Propriétaires de la Ville L'Association des Propriétaires de la Ville de Mackayville de Mackayville Proprietors' Association of the Town Proprietors' Association of the Town of Mackayville of Mackayville Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier mars 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Roméo Houde, agent d'affaires, Robert Nelson, vérificateur, Frank Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieuteannt-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Roméo Houdc, business agent, Robert Nelson, auditor, Frank Kenvis, 1092 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1962, Tome 8L, N° 17 Kenvis, importateur, tous de Mackayville, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Sauvegarder les intérêts moraux, économiques et sociaux, concernant les diverses classes de la société cri général, pour le territoire de Mackayville, sous le nom de \"L'Association des Propriétaires de la Ville de Mackayville\" \u2014 '\"Proprietors' Association of the Town of Mackayville\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Mackayville.district judiciaire de Montréal' Daté du bureau du Procureur général, le premier jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.importer, all of Mackayville, judicial district of Montreal, for the following purposes: To protect the moral, economic and social interests concerning the divers classes of society in general, for the territory of Mackayville, under the name of \"L'Association des Propriétaires de la Ville de Mackayville\" \u2014 \"Proprietors' Association of the Town of Mackayville\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head oflice of the corporation will be at Mackayville, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this first dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32123 Deputy Attorney General.L'Association des Taxis de Trois-Pistoles L'Association des Taxis de Trois-Pistoles Avis est donné qu'en vertu dos dispositions de la troisième partie do la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur do la province de Québec, des lettres patentes en date du onze mars 1952, constituant, en corporation sans capital-actions: Léonard Guérette, Joseph Mahoncy, Laurent Lavoie, Gérard Lagacé, Raymond Dumont, Philias Dumont, Patrice Guérette, Jean-Marc Rousseau, tous taxis, do Trois-Pistoles, district judiciaire de Ka-mouraska.pour les objets suivants: Contribuer à l'amélioration du service de taxi dans les limites de la Ville do Trois-Pistoles et donner une plus grande satisfaction au public, sous le nom de \"L'Association des Taxis de Trois-Pistoles\".Le montant auquel sont, limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est.de $3,01)0.Le siège social de la corporation sera à Trois-Pistoles.district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le onzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.I.amendait Homes Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sixième jour de février 1952, constituant en corporation Hyman Eric Feigelson, avocat, James Topping, John DiMassino, tous deux surintendants, Toshiko Nakatsuka, dactylo, tous des cité et district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, préposés aux travaux d'excavation et constructeurs, sous le nom de \"Laurendale Homes Limited\", avec un capital de $100,000 divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DESILETS.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Léonard Guérette, Joseph Mahoney, Laurent Lavoie, Gérard Lagacé, Raymond Dumont, Philias Dumont, Patrice Guérette.Jean-Marc Rousseau, all taxis, of Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To contribute to the improvement of the taxi service in the limits of the town of Trois-Pistoles and give greater satisfaction to the public, under the name of \"L'Association des Taxis de Trois-Pistolcs\".The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $3,000.The head office of the corporation will be at Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Laurendale Homes Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating Hyman Eric Feigelson, advocate, James Topping, John DiMassino, both superintendents, Toshiko Nakatsuka, typist, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes To carry on the business of general contractors, excavators, and builders, under the name of \"Laurendale Homes Limited\", with a capital stock of $100,000 divided into 2,500 common shares of a par value of $10 each and 750 pi eferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Le Champ de Courses sous Harnais de Le Champ de Courses sous Harnais de Jonquièrc Limitée Jonquièrc Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol 84, No.17 1093 etc accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze mars 1952, constituant en corporation Richard Savard, Fcrnand Savard, Maurice Sa-vard, tous forgerons, de Jonquièrc district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants Organiser et exploiter des courses de chevaux ou autres animaux, d'automobiles, sous le nom de \"Le Champ de Courses sous Harnais de Jon-quière Limitée\", avec un capital de S40,000 divisé en 403 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera sur la rue St-Pierre, en la ville de Jonquièrc, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le onzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Le Palais des Sports lue.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit février 1952, constituant en corporation: Wilbrod Bherer, c.r., avocat, Marcelle Vachon, sténographe, tous deux de Québec, Jacques Juneau, avocat, de Ste-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Faire le commerce d'articles de sport, sous le nom de \"Le Palais des Sports Inc.\", avec un capital de $-10,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du procureur général, le vingt-huitième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Les Entreprises Générales de Montréal, Canada, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize mars 1952, constituant en corporation: Bruno-Y.Perron, commis, Orner Paradis, menuisier, Albert La vallée, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire les affaires générales d'une compagnie d'immeubles et de développement d'affaires connexes au commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Entreprises Générales de Montréal, Canada, Limitée\", avec un capital de $39,900 divisé en 399 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treizième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of March, 1952, incorporating Richard Savard, Fernand Savard, Maurice Savard, all blacksmiths, of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes To organize and operate horse races, other animal races, and automobile races, under the name of \"Le Champ dc Courses sous Harnais de Jonquière Limitée\", with a capital stock of $10,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be on St-Pierre Street, in the town of Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the oflice of the Attorney General, this eleventh dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Le Palais des Sports Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of February, 1952, incorporating: Wilbrod Bherer, Q.C, advocate, Marcelle Vachon, stenographer, both of Quebec, Jacques Juneau, advocate, of Ste-Foy, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in articles of sport, under the name of \"Le Palais des Sports Inc.\", with a capital of $40,000 divided into 100 common shares of $100 each, and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of February.1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Les Entreprises Générales de Montréal, Canada, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of March, 1952, incorporating: Bruno Y.Perron, clerk, Omer Paradis, joiner, Albert Lavalléc.accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a General real estate business to deal and in any business pertaining thereto under the name of \"Les Entreprises Générales de Montréal, Canada, Limitée\", with a capital stock of $39,900 divided into 399 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Levinoff Meat Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sixième jour de février 1952, constituant en corporation Leo Rosentzveig, Manuel Shacter, tous deux avocats, de la cité de Montréal, Alice Levinoff Meat Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating Leo Rosentzveig, Manuel Shacter, both advocates, of the City of Montreal, Alice Axelrod, of the 1004 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N* 17 Axelrod, de la cité d'Outremont, Manuel A.Men-dell, C.R., avocat, de la cité de \"Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Exercer le commerce de boucheries et salaisons, sous le nom de \"Levinoff Meat Products Ltd.\", avec un capital de 800,000 divisé en G00 actions ordinaires de 850 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal, Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.City of Outremont, Manuel A.Mcndcll, Q.C., advocate, of the City of Westmount, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes To carry on the business of butchers, and packers, under the name of \"Levinoff Meat Products Ltd.\", with a capital stock of SG0.000 divided into 000 common shares of §50 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head oflice of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth dav of Februarv, 1952.L.DÉSILETS, 32123-0 Deputy Attorney General.Levis Motors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2.chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du treize mars 1052, constituant en corporation Pernand Sirois.comptable, de Sillery, Georges Baril, Athanase Siraard, tous deux commerçants, de Québec, tous'du district judiciaire deQuébeo.pour les objets suivants Agir comme garagistes, sous le nom de \"Levis Motors Ltd\", avec un capital de 890,000 divisé en 900 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le treizième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Levis Motors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth of March, 1952, incorporating Fcrnand Sirois.accountant, of Sillery, Georges Baril, Athanase Simard, both dealers, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes To act as garage-keepers, under the name of \"Levis Motors Ltd\", with a capital stock of $90,000, divided into 900 common shares of S100 each, The head office of the company will be at Levis, judicial district of Quebec.Dated at the oflice of the Attorney General this thirteenth dav of March, 19o2.L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.L.J.Trempe Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies île Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six février 1952, constituant en corporation: Louis-Joseph Trempe, marchand, Jeanne d'Arc, Trempe, ménagère, épouse de Louis-Joseph Trempe, tous deux de Sorel, Daniase Paul, gérant, de Ste-Anne de Sorel, tous du district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tabacs, cigarettes, aliments, épicerie, sous le nom de \"L.J.Trempe Incorporée\", avec un capital de $200,000 divisé en 500 actions ordinaires de 8100 chacune et en 1,500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général.32423-0 L.DÉSILETS.L.J.Trempe Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating: Louis-Joseph Trempe, merchant, Jeanne d'Arc Trempe, housewife, wife of Louis-Joseph Trempe, both of Sorel, Damasc Paid, manager, of Ste-Anne de Sorel, all of the judicial district of Richelieu, for the following purposes: To deal in tobaccos, cigarettes, foodstuffs, groceries, under the name of \"L.J.Trempe Incorporée\", with a capital stock of 8200.000 divided into 500 conmion shares of S100 each and into 1,500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-sixth dav of Februarv, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Magneto Auto Electric Limitée Avis est donné qu'en vertu do la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1952, constituant on corporation: J.-Adrien Meunier, avocat,Victor Carrières, comptable, Roger Gagnon, comptable agréé, tous dos cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de réparations de moteurs, sous le nom de \"Magneto Auto Magneto Auto Electric Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1952, incorporating: J.Adrien Meunier, advocate, Victor Carrières, accountant, Fogcr Gagnon, chartered accountant, all of the city and judicial district of Montreal for the following purposes: To carry on the business and deal in the repairs of motors under the name of \"Magneto Auto QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1095 Electric Limitée\", avec un capital dcS40,000 divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 12S0 rue Papineau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sixième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Master Refrigeration Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mars 1952, constituant en corporation Al-cide Normandin, propriétaire de taxis, Léon-A.Forget, électricien, Charles-Edouard Bertrand, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivantsr Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes d'appareils frigorifiques, sous le nom de \"Master Refrigeration Supplies Ltd\", avec un capital de 840,000 divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et en 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le troisième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Medical Arts Buildings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1951, des lettres patentes en date du vingt-sixième jour de février 1952, constituant en corporation Philip Fischcl Vineberg, Neil Franklin Philips, tous deux avocats, de la cité de Westmount, Jack Lightstonc, avocat, Yvonne Bélanger, secrétaire, Imclda Langlois, commis, tous trois de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants Acquérir et négocier une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Medical Arts Buildings Ltd.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 8,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de 810,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-sixième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Electric Limitée\", with a capital stock of 810,000 divided into 400 shares of S100 each.The head oflice of the company will be at 12S0 Papineau Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Master Refrigeration Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been > issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1952, incorporating Alci le Normandin, taxicab-owner, Léon A.Forget, electrician, Charles-Edouard Bertrand, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes To manufacture and to deal in all kinds of refrigeration apparatus, under the name of \"Master Refrigeration Supplies Ltd.\", with a capital stock of 810,000 divided into 2,500 common shares of a par value of S10'each and into 150 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Medical Arts Buildings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of February, 1952, incorporating Philip Fischcl Vineberg, Neil Franklin Phillips, both advocates, of the City of Westmount, Jack Lightstonc, advocate, Yvonne Bélanger, secretary, Imelda Langlois, clerk, all three of the City of Montreal, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes To acquire and deal with a certain immovable property, under the name of \"Medical Arts Buildings Ltd.\" The capital stock of the company is divided into 8.000 common shares having no nominal or par value, arrd the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be 840,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of Februarv, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney Gcnecal.Metro-Graphic Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, des lettres patentes en date du huitième jour de mars 1952, constituant en corporation: Benjamin Shulman, Samuel Alexander Shulman, tous deux avocats, Eileen Dawson, secrétaire, Moc Silvcrstonc, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Metro-Graphic Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eight day of March, 1952, incorporating: Benjamin Shulman, Samuel Alexander Shulman, both advocates, Eileen Dawson, secretary, Moe Silverstonc, clerk, all of the City and Jrrdicial District of Moirtreal, for the following purposes: 1096 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 Exercer l'industrie ou le commerce comme imprimeurs et éditeurs en général, sous le nom de \"Metro-Graphic Corporation\", avec un capital de 815,000 divisé en 1500 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Mirose Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies minières de la province de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour de mars 1952, constituant en corporation: Mil-ton Lowen Klein, avocat,Lcwis J.Manolson.coinp-tablc agréé, Micheal Drazner, étudiant en Loi, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier une certaine propriété immobilière sous le nom de \"Mirose Limited\", avec un capital de 850.000 divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Montmagiiy Copper Corporation Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a cté accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de mars 1952, constituant en corporation: Raymond Lebœuf, avocat, Gisèle Behocaray, Liliane Cloutier, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais, sous le nom de \"Montmagny Copper Corporation Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de S4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions d'une valeur au pair 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au-delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à 266 ouest, rue St-Jacqucs, chambre 412, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Mount Royal Securities Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1952, constituant en corporation: Jean-Jacques Hamel, avocat, de Terrebonne, district judiciaire de Terrebonne, Marie-Anna Savard, Thérèse Trudeau, toutes deux secrétaires, To carry on the trade or business of general printers, publishers, under the name of \"Metro-Graphic Corporation\", with a capital stock of SI5,000 divided into 1500 common shares of 810 each.The head oflice of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eight dav of March, 1952.L.DÉSILETS.32423-o Deputy Attorney General.Mirose Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of March, 1952, incorporating: Milton Lowen Klein.Advocate, Lewis J.Manolson, Chartered Accountant, Micheal Drazner, Student-Law, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with a certain immovable property, under the name of \"Mirose Limited\", with a capital stock of 850,000 divided into 300 common shares of SI00 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Montmagny Copper Corporation Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1952, incorporating: Raymond Lebœuf, advocate, Gisèle Behocaray, Liliane Cloutier, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Montmagny Copper Corporation Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of S 1,000,000 divided into 4,000,000 shares of SI each par value.The shareholders shall incur no personal res-portability in execess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will be at 266 St.James St., West, Room 412, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-o Deputy Attorney General.Mount Royal Securities Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1952, incorporating: Jean Jacques Ila-mel, advocate, of Terrebonne, judicial district of Terrebonne, Marie Anna Savard, Thérèse Trudeau, both secretaries, of the city and judicial QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1097 des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de valeurs mobilières, sous le nom de \"Mount Royal Securities Corporation Ltd\", avec un capital de S40.000 divisé en 1,000 actions communes de S10 chacune, et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Mount Royal Suburban Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du troisième jour de mars 1952, constituant en corporation: Ernest William Mockridgc, gérant, John Lawrence McCrory, commis, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et.district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'agence et de courtage de développement d'immeubles dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Mount Royal Suburban Realties Ltd.\" Le capital-actions de la compagnie sera composé de 200 actions sans valeur nominale ou au pair: le montant avec lequel la compagnie exercera son commerce sera fixé a la somme de $1,000.Le siège social de la compagnie sera à Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le troisième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.National Stevedoring Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour de mars 1952, constituant en corporation: Clarence Francis McCaffrey, procureur et conseil en loi de la Reine, Joseph Patrick Noonan, procureur, tous deux de la cité de Montréal, Mildred Callaghan, secrétaire, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général d'arrimage, sous le nom de \"National Stevedoring Company Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinquième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.district of Montreal, for the following purposes: To deal in movable securities, under the name of \"Mount Royal Securities Corporation Ltd.\".with a capital stock of S 10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Mount Royal Suburban Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March, 1952, incorporating: Ernest William Mockiidge, manager, John Lawrence McCrory.clerk.Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry a general realties development agency and brokerage business in all its branches, under the name of \"Mount Royal Suburban Realties Ltd.\".The capital stock of the Company shall consist of 200 shares without nominal or par value: the amount with which the Company will carry on its business is to be fixed at the sum of Si,000.The head oflice of the Company will be at the Town of Mount Royal, Judicial District of Mont» real.Dated at the office of the Attorney General, this third day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-o Deputy Attorney General.National Stevedoring Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of March, 1952, incorporating: Clarence Francis McCaffrey.Barrister and Queen's Counsel, Joseph Patrick Noonan, Barrister, both of the City of Montreal, Mildred Callaghan, Secretary, of the City of Outremont, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the general business of stevedoring, under the name of \"National Stevedoring Company Limited\", with a capital stock of $10,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will beat Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this fifth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Nelly's Chocolates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies tie Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour de février 1952, constituant en corporation: Theodore Camber, administrateur, June Kirlin, Joyce Hogg, sténographes Micheal Greenblatt, Samuel Godinsky, Harry Blank, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Nelly's Chocolates Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of February, 1952, incorporating: Theodore Camber, executive, June Kirlin, Joyce Hogg, stenographers, Micheal Greenblatt, Samuel Godinsky, Harry Blank, advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the follow-ing purposes: 1098 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 Manufacturer, faire le commerce et négocier To manufacture and deal in or with chocolates, des chocolats, des grains, céréales et autres ali- grains, cereals and other food and farm products ments, produits, de la ferme et accessoires, sous and accessories, under the name of \"Nelly's Cho-nom de \"Nelly's Chocalates Inc.\", avec un capital colates Inc.\", with a capital stock of $40,000 divide $40,000 divisé en 300 actions privilégiées ded into 300 preferred shares having a par value ayant une valeur au pair de $100 chacune et of $100 each, and 100 common shares having a 100 actions ordinaires ayant une valeur au pair par value of $100 each, de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head oflice of the Company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt- Dated at the office of the Attorney General neuvième jour de février 1952.this twenty-ninth day of February, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DESILETS, 32423 L.DÉSILETS.32423-0 Deputy Attorney General.Nordie Development Corporation Nordic Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été 'accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the fourth day du quatrième jour de mars 1952.constituant en of March.1952, incorporating: Edward William corporation: Edward William Rowat, Patrick Rowat.Patrick Emmet Kierans, John Brooke Emmet Kierans, John Brooke Claxton, tous avo- Claxton, all advocates, Elisabeth Agnès Greens- cats, Elisabeth Agnes Greensladc, Mildred Tay- lade, Mildred Taylor, stenographers, all of the lor, sténographes, tous des cité et district judici- City and Judicial District of Montreal, for the aire de Montréal, pour les objets suivants: following purposes: Acquérir, développer et faire le commerce de To acquire, develop, and deal with lands or terrains ou d'intérêts en iccux, avec ensemble interests therein, together with any buildings or toutes bâtisses ou structures, sous le nom de structures, under the name of \"Nordic Develop- \"Nordic Development Corporation\".ment Corporation\".Le capital-actions de la compagnie est divisé The capital stock of the company is divided en 2000 actions sans valeur nominale ou au pair into 2000 shares having no nominal or par value, et en 500 actions privilégiées de $100 chacune, et and into 500 preferred shares of $100 each, and le montant avec lequel la compagnie commencera the amount with which the company will commcn- ses opérations sera de $15,000.ce its operations will be $15.000.Le siège social de la compagnie sera à 6001 The head office of the Company will be at.Chemin Côtc-dc-Licsse, paroisse de St-Laurent, 6001 Côte-dc-Liesse Road, Parish of St.Laurent, district judiciaire de Montréal.Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le qua- Dated at the oflice of the Attorney General trième jour de mars 1952.this fourth day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423 L.DÉSILETS.32-123-o Deputy Attorney General.Northen Paving and Ready Mix Ltd.Northen Paving and Ready Mix Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the -partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- province de Québec, représenté par M.Alfred incc of Quebec, represented by Mr.Alfred Moris- Morisset, conformément à l'article 2, chapitre set, in conformity with section 2, chapter 276, 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of quinze mars 1952, constituant en corporation : March.1952, incorporating: Jean Berehmans Jean-Berchmans Bélanger, Hubert Desjardins.Bélanger, Hubert Desjardins, Marcel Basticn, all Marcel Basticn, tous comptables, des cité et dis- accountants, of the city and judicial district of trict judiciaire de Montréal, pour les objets sui- Montreal, for the following purposes: vants: Agir comme contracteurs généraux, contrac- To act as general contractors, excavation conteurs en excavation, sous le nom de \"Northern tractors, under the name of \"Northern Paving Paving and Ready Mix Ltd.\", avec un capital de and Ready Mix Ltd.\", with a capital stock of $150,000 divisé en 750 actions ordinaires de S100 $150,000, divided into 750 common shares of $100 chacune et 750 actions privilégiées de S100 cha- each, and 750 preferred shares of 8100 each, cune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, quinzième jour de mars 1952.this fifteenth day of March, 1952.L'Assistant-procureur general, L.DÉSILETS, 32423-0 L.DÉSILETS.' 32423 Deputy Attorney General.Onsite Construction (Quebec) Limited Onsite Construction (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I partie de la Loi des compagnies de Québec, il a of the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the twenty- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26tk, 1962, Vol.8i, No.17 1099 du vingt-septième jour de février 1952,constituant en corporation: David Goodman, Jack Lightstone tous deux avocats, Yvonne Bélanger, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs et constructeurs, sous le nom de \"Onsite Construction (Quebec) Limited\", avec un capital de §20,000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-septième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, .32123 L.DÉSILETS.Pcpe's Restaurant, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie do la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province do Québec, des lettres patentes en date du douzième jour de mars 1952, constituant en corporation: John De Vincenzo, conducteur, Salvatore Cipolla, cuisinier.Lionel Lefebvrc, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"Pcpe's Restaurant, Inc.\", avec un capital de S35,000 divisé en 350 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.seventh day of February, 1952, incorporating: David Goodman, Jack Lightstone, both advocates, Yvonne Bélanger, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors and builders, under the name of \"Onsite Construction (Quebec) Limited\", with a capital stock of 820,000 divided into 2,000 common shares of 810 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this twenty-seventh dav of Februarv, 1952.L.DÉSILETS, 32423-o Deputy Attorney General.Pope's Restaurant, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of March, 1952, ' incorporating: John De Vincenzo, conductor, Salvatore Cipolla, cook, Lionel Lefebvrc, accoutant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurants, under the name of \"Pepe's Restaurant, Inc.\", with a capital stock of 835,000 divided into 350 common shares of S100 each.The head ofhec of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Pfaff Sewing Centre of Montreal Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuvième joui de février 1952, constituant en corporation: Robert Harold EarleWalker, avocat et conseil en loi do la Reirre, Roger Louis Beaulieu, avocat, tous deux de la cité de Montréal, George Anthony Allison, avocat, de Ville Mont-Royal, toirs du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général de toutes sortes de machines à coudre ainsi que leurs accessoires et pièces, sous le nom de \"Pfaff Sewing Centre of Montreal Ltd.\", avec un capital de S30.000 divisé en 3,000 actions d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté drr bureau du Procureur général, le vingt-neuvième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32123 L.DÉSILETS.Plomberie Horhelaga Ltée Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq mars 1952, constituant en corporation: Paul Galt Michaud, avocat, Gretta Wainwright, Louise Héon, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme mécaniciens, soudeurs, fondeurs, plombiers, couvreurs, machinistes, Pfaff Sewing Centre of Montreal Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of February, 1952, incorporating: Robert Harold Earle Walker, advocate and Queen's Counsel, Roger Louis Beaulieu, advocate, both of the City of Montrcal.jGeorgc Anthony Allison, advocate, of the Town of Mount Royal, all of the judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in all kinds of sewing machines and accessories and parts, under the name of \"Pfaff Sewing Centre of Montreal Ltd.\", with a capital stock of 830,000 divided into 3,000 shares of the par value of 810 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-0 Deputy Attorney General.Plomberie Ilochelaga Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date* the fifth day of March, 1952, incorporating: Paul Gait Midland, advocate, Gretta Wainwright, Louise Héon, Secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as mechanics, solderers, founders, plumbers, roofers, machinists, metal 1100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 20 avril 1962, Tome 84, N° 17 ouvrier en métaux de tous genres sous le nom de \"Plomberie Ho-beluga Ltée\", avec un capitul de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le cinquième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Quebec Glassheat Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mars 1952, constituant en corporation: Henri Beaupré, avocat, J.-Adrien Boivin, entre-neur, Pierre Tardif, entrepreneur-électricien.Jean-Paul Beaupré, commis de bureau, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce tic tous genres de système de chauffage ou de contrôle, sous le nom de \"Quebec Glassheat Limited\", avec un capital de $35,000 divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le sixième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Radio Publicité Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf février 1952, constituant en corporation: Jean-Noël Lanctôt, avocat, Ilugucttc Barbe\"u, secrétaire, tous deux de Montréal.Paul-Émile LeJour, avocat, de Lachine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets shi-ants: Établir, maintenir et conduire une entreprise général de publicité, sous le nom de \"Radio Publicité Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 200 actions de S50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuvième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général.32423-0 L.DÉSILETS.workers, of all kinds, under the name of \"Plomberie Hochelaga Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Quebec Glassheat Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day day of March, 1952.incorporating: Henri Beaupré, advocate, J.Adrien Boivin, contractor.Pierre Tardif, electrical contractor.Jean Paul Beaupré*, office clerk, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of heating or central systems, under the name of \"Quebec Glasshcat Limited\", with a capital stock of $35,000 divided into 1,500 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Radio Publicité Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-riinth day of February, 1952, incorporating: Jean Noël Lanctôt, advocate, Huguettc Barbeau, secretary, both of Montreal, Paul-Emile LeJour advocate, of Lachine, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To establish, maintain and carry on a general publicitv business, under the name of \"Radio Publicité Inc.\".with a capital stock of $10,000 divided into 200 shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentv-ninth day of Februarv, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Regional Propan Gas Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1952, constituant en corporation: M.Ronaldo Tapin, courtier en immeubles, Marie-Ange Tremblay, épouse contractuelle-ment séparée de biens dudit Ronaldo Tapin, tous deux de la cité de Chicoutimi, Adrien Grégoire, commis, de Port-Alfred, tous du district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants : Manufacturer et faire le commerce des gaz propane et butane, sous le nom de \"Regional Propan Gus Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 4Q0 actions de $100 chacune.Regional Propan Gas Limited Notice is hereby, given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1952, incorporating: Mr.Ronaldo Tapin, real estate broker, Marie-Ange Tremblay, wife separated as to property by marriage contract, of the said Ronaldo Tapin, both of the city of Chicoutimi, Adrien Grégoire, clerk, of Port-Alfred, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture and deal in propane and butane gases, under the name of \"Regional Propan Gas Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 86th, 1958, Vol.81, No.17 1101 Le siège social de la compagnie sera à 551, Racine est, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, .32423-0 L.DÉSILETS.Richelieu Glassheat & Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit février 1952, constituant en corporation: Jacques Beaugrand-Champagne, technicien, de St-Hyacinthe, district judiciaire de St-Hyacinthe, George Costis, commerçant, Henri Masson, comptable agréé, tous deux de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme vendeurs, distributeurs et manufacturiers de matériaux de construction de toutes sortes, et plus spécialement en ce qui concerne les installations de chauffage, sous le \"Richelieu Glassheat & Supplies Inc.\", avec un capital de S40,000 divisé en 400 actions ordinaires de S50 et en 400 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Hyacinthe, district judiciaire de St-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.S.&.L.Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de mars 1952,- constituant en corporation: Bill Laufcr, manufacturier, Dave Szalavetz, manufacturier.Joyce Hogg, June Kir-lin, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le négoce de tissus et vêtements de toute sortes, sous le nom de \"S.& L.Sportswear Inc.\" avec un capital de 810.000 divisé en 50 actions ordinaires ayant une valeur au pair de 8100 chacune et 50 actions privilégiées ayant une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DESILETS.Service Social du Diocèse de St-Jean-dc-Québec Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit mars 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard-Marie Coderre, V.G., évêque coadjutcur, Jacques Cartier jr.: avocat, Roméo Marcoux, médecin, tous de St-Jean-de-Québec, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: \u2022 Secourir les familles en détresse, les enfants naturels, les personnes inadaptées, difficiles, irrégulières et délaissées, sous le nom de \"Service Social du Diocèse de St-Jean-de-Québec\".The head office of the company will be at 551, Racine East, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Deputy Attorney General, this eighth day of March.1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Richelieu Glassheat & Supplies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-cigth day of February, 1952, incorporating: Jacques Beaugrand-Champagne, technician, of St-Hyacinthe, judicial district of St-Hyacinthe, George Costis, dealer, Henri Masson, chartered accountant, both of Montreal, judicial district of* Montreal, for the following purposes: To do business as salesman, distributors and manufacturers of building materials of all kinds, and more particularly in that which concerns heating installations, under the name of \"Richelieu Glassheat &.Supplies Inc.\", with a capital stock of 840,000 divided into 400 common shares of S50 and into 400 preferred shares of 850 each.The head office of the company will be at St-Hyacinthc, judicial district of St-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-cighth dav of Februarv, 1952.L.DESILETS, 32423 \u2022 Deputy Attorney General.S.&.L.Sportswear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of March, 1952, incorporating: Bill Laufer, manufacturer.Dave Szalavetz.manufacturer, Joyce Hogg, June Kirlin.all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with fabrics and clothing of every sort, under the name of \"S.& L.Sportswear Inc.\", with a capital stock of 810,000 divided into 50 common shares having a par value of 8100 each, and 50 preferred shares having a par value of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal.Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Service Social du Diocese de St-Jean-de-Québec Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eight day of March, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard Marie Coderre, V.G., coadjutor Bishop, Jacques Cartier, Jr., advocate, Roméo Marcoux, physician, all of St-Jean-de-Québec, judicial district of Iberville, for the following purposes: To assist families in distress, foundlings, unfit, difficult, erratic and abandoned persons, under the name of \"Service Social du Diocèse de St-Jean-de-Québec\". 1102 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8100,000.Le siège social de la corporation sera à St-Jean-de-Québec, district judiciaire d'Ibcrville.Daté du bureau du Procureur général le huitième jour de mars 1952.\u2022 L'Assistant-procureur général, 32123-0 L.DÉSILETS.Sherbrooke Glassheat & Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit février 1952, constituant en corporation: Jacques Beaugrand-Champagne, technicien, de St-Hyacinthe, district judiciaire de St-Hyacinthe, Georges Costis, commerçant, Henri Masson, comptable agréé, tous deux des cité et district judiciaire île Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme vendeurs, distributeurs et manufacturiers de matériaux dé construction de toutes soi tes, et plus spécialement en ce qui concerne les installations de chauffage, sous le nom de \"Sherbrooke Glassheat & Supplies Inc.\", avec un capital de S 10,000 divisé en 400 actions ordinaires de S50 chacune et en 400 actions privilégiées de S50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huitième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Transgaspésien Aérien Ltée Transgaspcsian Airline Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément a l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q., 1941.des lettres patentes en date du quinze mars, 1952, constituant en corporation: Michel Poubot, pilote aviateur, de Gaspé, distrie' judiciaire de Gaspé, Camille Tail Ion, courtier d'assurances, de Québec, Jacques de Billy, avocat, de Lévis, tous deux du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie de transport de marchandises, passagers et de malle par la voie des airs, sous le nom de \"Transgaspésien Aérien Ltée\"\u2014\"Transgaspcsian Airline Ltd.\", avec un capital de S80.000 divisé en 300 actions ordinaires de S100 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Gaspé, district judiciaire de Gaspé.Daté du bureau du Procureur général le quinzième jour de mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.United Knit & Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu.de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de février 1952, constituant en corporation: Harry Blank, procureur June Kirlin, secrétaire, Joyce Hogg, réception- The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at St-Jean-de-Québec, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this eight day of March, 1952.L.DÉSILETS 32423 Deputy Attorney General.Sherbrooke Glassheat & Supplies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eight day of February, 1952, incorporating: Jacques Beaugrand-Champagne, technician, 'of St-Hyacinthe, judicial district of St-Hyacinthe.Georges Costis, dealer, Henri Masson, chartered accountant, both of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To do business as salemen distributors and manufacturers of building materials of all kinds, and more particularly that which ooncerns heating installations, under the name of \"Sherbrooke Glassheat & Supplies Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $50 each, and into 400 preferred shares of S50 each.The head office of the company will be at Slvcrbrooke, judicial district of St-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eight dav of Februarv.1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Transgaspésien Aérien Ltée Transgaspcsian Airline Ltd.* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1911.bearing date the fifteenth day of March, 1952, incorporating:*Michel Pouliot, aviation pilot of Gaspé, judicial district of Gaspé, Camille Taillon insurance broker, of Quebec, Jacques de Billy, advocate, of Levis, the two latter of the Judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate a company for the transportation, by air, of merchandise, passengers and mail, under the name of \"Transgaspésien Aérien Ltée\"\u2014\"Transgaspcsian Airline Ltd.\", with a capital stock of $80,000 divided into 300 common shares of 8100 each, and 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at (Jaspé, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.United Knit & Sportswear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of February, 1952, incorporating: Harry Blank, attorney, June Kirlin, secretary, Joyce Hogg, receptionist, all of the City and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.81, No.17 1103 nistc, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun des commerces de marchands de vêtements, pelletiers, tailleurs, drapiers, merciers, bonnetiers, marchands de modes, costumiers, gantiers, et chapeliers, sous le nom de \"United Knit & Sportswear Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huitième jour de février 1052.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on all of any of the businesses of clothiers, furriers, tailors, drapers, haberdashers, hosiers, milliners, costumers, glovers, and hatters, under the name of \"United Knit & Sportswear Inc.\", with a capital stock of S40,000 divided into 200 common shares having a par value of 8100 each and 200 preferred shares having a par value of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of February.1952.L.DESILETS, 32423-o Deputy Attorney General.Will-Jon Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 3, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour de février 1952, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat, et Conseil en Loi du Roi, Joseph R.Hoffman, Boris Garmaisc, tous deux avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une corporation d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Will-Jon Corp.\".Le capital de la compagnie est divisé en 2,000 actions sans valeur nominale ou au pair et 700 actions privilégiées de S100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations ne sera pas moindre de S 17,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de février 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Will-Jon Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been-issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-fifth day of February, 1952, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and King's Counsel, Joseph R.Hoffman, Boris Garmaise, both advocates, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment corporation, under the name of \"Will-Jon Corp.\".The capital stock of the company is divided into 2,000 shares having no nominal or par value, and into 700 preferred shares of S100 each, and the amount with which the company will commence its operations will be not less than S17.000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32423-Q Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Auberge \"Halfwav\" Inc.\"Halfway\" Inn Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 mars 1952, à la compagnie \"Auberge \"Halfway\" Inc.\" \u2014 \"Halfway.Inn Inc.\", modifiant une disporition de ses lettres patentes de la manière énoncée dans la résolution adoptée le 8 mars 1952.Daté du bureau du Procureur général le 17 mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Auberge \"Halfwav\" Inc.\"Halfway\" Inn Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of March, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Auberge \"Halfway\" Inc.\" \u2014 \"Halfway Inn Inc.\", modifying a provision of its letters patent in the manner set forth in the resolution adopted on March 8, 1952.Dated at the office of the Attorney General this 17th clay of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Cycles Automoto (Canada) Ltée Cycles Autonioto (Canada) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémn-taires, en date du 7 janvier 1952, à la compagnie \"Cycles & Sports Agencies Limited\" \u2014 \"Les Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act supplementary letters patent bearing date the 7th day of January, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Cycles & Sports Agencies Limited\" \u2014 \"Les Agences d'arti- 1104 GAZETTE OFFICIELLE DE QVÈBEC, Québec, 20 avril 1952, Tome 67,, N° 17 Agences d'articles de Sport et de Cycles Limitée\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres en date du 23 octobre 1950, changeant son nom en celui de \"Cycles Automoto (Canada) Ltée\".Daté du bureau du Procureur général le 7 janvier 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Empire Oil & Minerals lue.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 mars 1952, à la compagnie \"Decary Metals Incorporated\" (No Personal Liability), constituée en corporation par lettres patentes du 31 janvier 1952, changeant son nom en celui de \"Empire Oil & Minerals Inc.\" (No Personal Liability), et étendant ses pouvoirs à tels autres objets mentionnés dans le règlement adopté le 18 mars 1952.Daté du bureau fu Procureur général le 20 mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.J.E.Clément Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 mars 1952, à la compagnie \"J.E.Clement Incorporated\", 1.ratifiant son règlement numéro 27 réduisant son capital-actions de $300,000 à $75,000 en réduisant la valeur au pair des actions de $100 a $25 chacune; 2.ratifiant son règlement numéro 28 portant son capital-actions de $75,000 à 8375,000 par la création de 30,0000 actions privilégiées nouvelles de $10 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement; 3.changeant son nom en celui de \"J.E.Clément Inc.\".Daté du bureau du Procureur général le 14 mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Lachine Amusement Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 17 mars 1952, à la compagnie \"Lachine Amusement Limited\", ratifiant son règlement numéro 24, subdivisant 400 actions privilégiées de $100 chacune non émises en 4,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général le 17 mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Les Placements Duvernay Inc.Duvernay Investments Inc.cles de Sport et de Cycles Limitée\" incorporated under Part I of the Quebec Companies Act by letters patent bearing date October 23, 1950, changing its name into that of \"Cycles Automoto (Canada) Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this 7th dav of January, 1952.; L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Empire Oil & Minerals Inc.Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of March, 1952, were issuer! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Decary Metals Incorporated\" (No Personal Liability), incorporated by letters patent dated January 31, 1952, changing its name into that of \"Empire Oil & Minerals Inc.\", (No Personal Liability), and extending its powers to such other purposes as mentioned in the by-law adopted March 18, 1952.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.J.E.Clement Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the fourteenth day of March, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"J.E.Clement Incorporated\", 1.ratifying its By-law No.27 decreasing its capital stock from $300,000 to $75,000 by reducing the par value of the shares from $100 to $25 each; 2.ratifying its By-laws No.28 increasing its capital stock from $75,000 to $375,000 by the creation of 30,000 new preferred shares of $10 each, subject to the rights and restrictions set forth in the said By-law; 3.changing its name into that of \"J.E.Clément Inc.\".Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of March, 1952.L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Lachinc Amusement Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of March, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Lachine Amusement Limited\", ratifying its By-law Number 24, subdividing 400 preferred shares of $100 each, unissued, into 4,000 preferred shares of $10 each, subject to the rights and restrictions set forth in the said By-law.Dated at the office of the Attorney General, this 17th day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Les Placements Duvernay Inc.Duvernay Investments Inc.Avis est par les présentes donné qu'en vertu Notice is hereby given that under Part I of de la première partie de la Loi des compagnies the Quebec Companies' Act, supplementary QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8/t, No.17 1105 de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 270, des lettres patentes supplémentaires en date du 11 mars 1952, à la compagnie \"Les Placements Duvernay Inc.\"\u2014\"Duvernay Investments Inc.\", 1.ratifiant son règlement N° 36: a) convetissant 1,719 actions ordinaires de S10 chacune de son capital autorisé sous forme de 1,719 actions privilégiées de $10 chacune; b) augmentant ce capital autorisé de S18.000 à $40,000 par la création de 419 actions ordinaires additionnelles de $10 chacune et de 1,781 actions privilégiées additionnelles de $10 chacune; c) énumérant les privilèges, droits et restrictions attachés aux actions privilégiées; 2.modifiant les dispositions des lettres patentes de la manière énoncée dans le règlement N° 37.Daté du bureau du Procureur général le 11 mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Victoria Construction Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 mars 1952, à la compagnie\"Victoria Construction Co.Limited\", ratifiant son règlement N° 25, lo \u2014 réduisant son capital-actions de $20,000 à $8,000 par l'annulation de 120 actions ordinaires de $100 cha-nc; 2° \u2014 portant son capital-actions de $8,000 à S60,000 par la création de 20 actions ordinaires additionnelles de S100 chacune et de 500 actions privilégiées nouvelles de S100 chacune, sujettes aux droits et retrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général le 14 mars 1952.L'Assistant-procureur général, 32423 L.DESILETS.Widgor & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, reprensenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 24 mars 1952, à la compagnie \"Wigdor & Stein Company\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 7 mai 1936, changeant son nom en celui de \"Wigdor & Sons Limited\".Daté du bureau du Procureur général le 24 mars 1952.>\"*** L'Assistant-procureur général, 32423 L.DÉSILETS.Wonderbar Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 28 mars 1952, à la.compagnie \"Leone's Restaurant Inc.\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes en date du 9 novembre 1943, sous le nom de \"Chez Maurice Danceland Corporation\", changeant son nom en celui de \"Wonderbar Ltd.\" letters patent, bearing date the eleventh day of March, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Les Placements Duvernay Inc.\"\u2014\"Duvernay Investments Inc.\", 1.ratifying its By-law No.36: «) converting 1,719 common shares of $10 each of its authorized capital into 1,719 preferred shares of S10 each; b) increasing said authorized capital from $18,000 to $40,000 by the creation of 419 additional common shares of $10 each and 1,781 additional preferred shares of S10 each; c) enumerating the privileges, rights and restrictions attaching to the preferred shares; 2.modifying the provisions of the letters patent in the manner set forth in By-law No.37.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Victoria Construction Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of March, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company\"Vic-toria Construction Co.Limited\", ratifying its By-law No.25, 1.\u2014 Reducing its capital stock of S20.000 to S8.000 by the cancellation of 120 common shares of S100 each; 2.\u2014 carrying its capital stock from S8,000 to $60,000 by the creation of 20 additional common shares of $100 each and of 500 new preferred shares of $100 each, subject to the rights and restrictions set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 14th day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Widgor & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date March 24, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company, \"Wigdor & Stein Company\", incorporated by letters patent under Part I of the Quebec Companies Act, bearing date May 7, 1936, changing its name into that of \"Wigdor & Sons Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this 24th day of March, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Wonderbar Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date March 2S, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Leone's Restaurant Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated November 9, 1943, under the name of \"Chez Maurice Danceland Corporation\" changing its name into that of \"Wonderbar Ltd\". 1106 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 Daté du bureau du Procureur général le 28 Dated at the office of the Attorney General mars 1952.this 28th day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423 L.DÉSILETS.32423 Deputy Attorney General.Wright Supplies Co.Ltd.Wright Supplies Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies Act, supplementary letters accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- patent, bearing date the 24th day of March, 1952.vince de Québec, représenté par M.Alfred Mo- were issued by the Lieutenat-Governor of the risset, conformément à l'article 2 de ladite loi, Province of Quebec, represented by Mr.Alfred S.R.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes Morisset, in conformity with section 2 of the supplémentaires en date du 24e jour de mars 1952, said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the compati la compagnie \"Wright Belting & Supplies ny \"Wright Belting & Supplies Limited\", incor-Limited\", constituée en corporation en vertu de la porated under Part I of the Quebec Companies première partie de la Loi des compagnies de Act by letters patent dated March 15th, 1931 Québec par lettres patentes en date du 15 mars changing its name to that of \"Wright Supplies 1934 changeant son nom en celui de \"Wright Co.Ltd.\".Supplies Co.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 2-Jc- Dated at the office of the Attorney General this jour de mars 1952.24th day of March, 1952.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 32423 L.DÉSILETS.32423-o Deputy Attorney General.Arrêtés en Conseil Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 412 Québec, le 17 avril 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"F\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité paritaire de l'Industrie de la boîte de carton dans la province de Québec a présenté au Ministre du Travail, une requête à l'effet d'amender le décret numéro 1884 du 12 novembre 1947, amendé par les arrêtés numéros 277.422-A, 748-D, 971-C, 1288-E, 1763-G et 1784-A des 4 et 30 mars, 19 et 27 mai, 29 septembre.23 et 29 décembre 1948, 883-C du 11 août 1949, 10S-B du 25 janvier 1950, 120-A du 1er février 1951 et 71-A du 31 janvier 1952, relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec.Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 1er mars 1952; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1884, soit modifié comme suit: 1° L'article I est radié et remplacé par le suivant: 1.Juridiction: a) Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend toute la Province de Québec à l'exception des districts ,'ud'ciaires de Kamouraska, Montmagny, Beauce, Arthabaska, St-François, Nicolet, Québec, Trois-Rivières, Roberval, Chicoutimi et Saguenay.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 412 Quebec, April 17, 1952.Present: The Licutenant-Governor-In-Council.Part \"F\" Concerning amendments of the decree relating to the paper box industry in the Province of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Joint Committee of the Paper Box Industry of the Province of Quebec has submitted to the Minister of Labour a request to amend the decree number 1884 of November 12, 1947, as amended by Orders in Council 277, 422-A.748-D, 971-C, 1288-E, 1763-G and 17S4-A of March 4 and 30.May 19 and 27, September 29, December 23 and 29, 1948, 883-C of August 11, 1949, 108-B of Jan-urary 25, 1950, 120-A of February 1, 1951, and 71-A of January 31, 1952, relating to the paper box industry in the province of Quebec; W'hereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of March 1, 1952; Whereas the objections set forth have been considered as required by the Act; » Be it enacted, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1884, be amended as follows: 1.Section I is deleted and replaced by the following: \"I.Jurisdiction: a) Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree comprises the entire Province of Quebec with the exception of the judicial districts of Kamouraska, Montmagny Beauce, Arthabaska, St.François, Nicolet, Quebec, Three Rivers, Roberval, Chicoutimi and Saguenay. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1107 Aux fins d'application, cette juridiction est di- For purposes of enforcement, this jurisdiction visée en deux zones de la façon suivante: is divided in two zones as follows: Zone I: L'Ile de Montréal et un rayon de 50 Zone I: The Island of Montreal and the terri-milles de ses limites en ligne droite, sous réserve tory included within a radius of 50 miles in a des territoires compris dans la zone II.straight line from its boundaries with the exception of the areas comprised in zone II.Zone II: Le reste de la juridiction territoriale, Zone II: The remainder of the territorial ju- y compris la municipalité de l'Epiphanie et le dis- risdiction , including the municipality of Epipha- trict judiciaire de Bedford.nie and the judicial district of Bedford.b) Juridictioyi industrielle: La juridiction indus- b) Industrial jurisdiction: The industrial ju-trielle du décret comprend la fabrication des bot- risdiction of the present decree comprises the les de carton, des boîtes faites d'imitation de bois, manufacturing of paper boxes, of wood imitation faites en parties ou finies avec papier, fibre, bois boxes, partly made or completed with paper, ou carton et de toutes autres boîtes à base de pul- fibre, wood or cardboard and of all other pulp or ])e ou papier non gaufré.Toutefois, le présent dé- paper boxes made of uncorrugated material, cret ne régit pas la fabrication des boîtes de car- However, the present decree does not apply to ton gaufré.manufacturing of corrugated paper boxes.c) Juridiction professionnelle: La juridiction c) Professional jurisdiction: The professional professionnelle du décret désigne et comprend jurisdiction of the decree designates and com-toute personne exécutant des opérations en quel- prises all persons performing any operation in any que sorte incidentes ou connexes à la fabrication way connected with or related to the production des boîtes de carton, soit dans un atelier spécia- of paper boxes, whether in trade plants, private, lise, une entreprise privée ou commerciale, ou industrial, commercial or any other establish-dans tout autre établissement et soit que telles ment, and whether such operations constitute opérations constituent le commerce principal de its principal business or are accessory to some telle entreprise, ou qu'elles soient secondaire à other business or enterprises.tout autre commerce ou occupation.\" 2° L'article III, est radié et remplacé par le 2.Section III is deleted and replaced by the suivant: following: \"III.Salaire minima: Le salaire minimum des \"III.Minimum Wage Rates: The minimum salariés affectés à la fabrication des boîtes, des wage rates of the employees working in the ma-chauffeurs de bouilloires, des mécaniciens de ma- nufacturing of boxes, of boiler fireman, station-chines fixes, des gardiens'et des salariés préposés ary enginemen, watchemen, those working in the à l'expédition, à la livraison, à l'entretien ou à la shipping and delivery departments, building and réparation des immeubles et machines, est le sui- machinery repair and maintenance men, shall be vant pour les catégories respectives de salariés the following for the respective categories of em-mentionnées ci-après: ployees- hereinafter mentioned: Taux horaires minima a) Salariées \u2014 Female employees: Minimum hourly rates \u2022 Zones Département des boîtes rigides \u2014 Set-up Department: I II Contremaîtresse \u2014 Forelady.$0.78 $0.74 Travailleuse à la main, classe \"A\" \u2014 Hand worker, class \"A\".0.72 0.68 Travailleuse à la main, classe \"B\" \u2014 Hand worker, class \"B\".0.64 0.61 Travailleuse posant étiquettes à la main \u2014 Hand labeller.0.62 0.59 Mécanicienne de machine à couvrir \u2014 Covering machine operator.0.64 0.61 Mécanicienne de machine à renforts \u2014 Staying machine operator 0.64 0.61 Mécanicienne de machine Stoke & Smith \u2014 Stoke & Smith machine operator.0.64 0.61 Mécanicienne de machine à poser les dessus \u2014 Top Piece machine operator.0.64 0.61 Mécanicienne de machine à poser les étiquettes \u2014 Labelling machine operator.0.64 0.61 Mécanicienne de gommeusc filée à la main \u2014 Hand fed gummer operator .0.62 0.59 Préposée à l'emballage et ficelage \u2014 Packer & tier.0.62 0.59 Pileuse de machine à coller 4 coins \u2014 Four-corner machine feder.0.62 0.59 Mécanicienne sur machine non-classifiées plus haut \u2014 Operators on machines not classified above.0.62 0.59 Département des boîtes pliantes \u2014 Folding Department: Contremaîtresse \u2014 Forelady.0.78 0.74 Mécanicienne de machine à piquer \u2014 Stitcher \"operator.0.64 0.61 Eplucheuse \u2014 Stripper.0.62 0.59 Plieuse \u2014 Folder.0.62 0.59 Préposée à l'emballage et ficelage \u2014 Packer and tier.0.62 0.59 Fileuse de machine Brightwood \u2014 Bright wood machine feeder.0.62 0.59 Fileuse de machine automatique à coller \u2014 Auto, Glueing machine feeder.0.62 0.59 Mécanicienne sur machine non-classifiées plus haut \u2014 Operators on machines not classified above.0.62 0.59 b) Echelle de base \u2014 Salariées \u2014 Basic wage scale \u2014 Female: L'échelle de base des salariées est le suivante \u2014 The basic wage scale of female employees shall be as follows: Premier trois (3) mois \u2014 First three (3) months.0.45 0.43 Deuxième trois (3) mois \u2014 Second three (3) months.0.50 0.47 Troisième trois (3) mois \u2014 Third three (3) months.0.55 0.52 Le temps de service acquis par chacune des sa- The period of service of an employee at the lariées au moment de l'entrée en vigueur du pré- time of the coming into force of the present de- 1108 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 sent décret doit être pris en considération pour crée shall be taken into consideration to deter- déterminer son salaire en regard de l'échelle de mine her wage rate in accordance with the above base ci-haut mentionnée.wage scale.c) Apprentissage \u2014 Salariées: c) Apprenticeship\u2014.Female employees: Premier semestre: 20% de moins que le mi- First six (6) months: 20% less than minimum nimum.rate.Deuxième semestre: 10% de moins que le mi- Second six (6) months: 10% less than mini-uimum.mum rate.Le nombre des apprenties ne doit pas dépasser The number of female apprentices shall not 20% du nombre total des salariées au travail pour exceed 20% of the total number of female ein-les opérations classifices ci-haut mentionnées.ployees engaged on the above classified operations.Nonobstant les dispositions de cet article, au- Notwithstanding the provisions of the present cune apprentie ne doit recevoir une rémunération section, no female apprentice shall receive a reinférieure au taux établi par l'échelle de base au- muneration less than the basic wage rate to which quel clic a normalement droit.Le taux établi she is normally entitled.The basic wage rates par l'échelle de base a préséance en tout temps.shall prevail at all times.Taux horaires minima d) Salariés \u2014 Male Employees: Minimum hourly rares Zones Département des boites rigides \u2014 Set-up Department: I II Contremaître \u2014 Foreman.S 1.36 S 1.29 Assistant contremaître \u2014 Ass't Foreman.1.20 1.14 ' Mécanicien \"creaser\" \u2014 Creasing operator .1.08 1.03 Mécanicien de marqueuse mitrailleuse \u2014 Scorer.1.08 1.03 Mécanicien de guillotine, 1ère classe \u2014 Cutter on knife, first class.1.08 1.03 Mécanicien de guillotine, 2e classe \u2014 Cutter on knife, second class.0.97 0.02 Mécanicien de monteuse simple \u2014 End piece operator sigle.0.96 0.91 ' Mécanicien de monteuse double \u2014 End piece operator double,.0.99 0.94 Mécanicien de machine à renforts à 4 coins \u2014 4 corner stayer operator.1.04 0.99 Filcur machine, à coller à 4 coins \u2014 Feeder, 4 corner glueing machine .0.88 0.84 Mécanicien de machine emporte-pièce \u2014 Punch operator.0.88 0.84 Préposé à la mise en train Stokc-Smith \u2014 Wrapper makercady man.1.03 0.98 Préposé à la scie circulaire \u2014 Circular saw operator.0.89 0.85 Bobineur \u2014 Slitter operator.0.91 0.86 Presscur dc rebuts \u2014 Bale press operator.0.87 0.S3 Mécanicien sur machines non-classifiées plus haut \u2014 Operator on machines not classified above.0.86 0.82 Département des boîtes pliantes \u2014 Folding Department: Contremaître \u2014 Foreman.$ 1.36 $ 1.29 Assistant-contremaître \u2014 Asst' Foreman.>.1.20 1.14 Faiseur dc matrice \u2014 Die maker.1.21 1.15 Assistant faiseur de matrice \u2014 Ass't Die maker.0.89 0.85 Préposé à la mise en train machine automatique à coller \u2014 Auto, glueing machine makercady man.1.13 1.07 Préposé à la mise en train machine Brightwood \u2014 Brightwood machine makeready man.'._.\u2022-\u2022 :.1.04 0.99 Filcur, machine Brightwood \u2014 Feeder, Brightwood machine.0.88 0.84 Préposé à la mise en train machine Indman \u2014 Indman machine makeready man.;.:.1-04 .0.99 Préposé à la mise en train machine à cirer \u2014 Waxing machine makeready man.;.\u2022.0.86 0.82 Piéposé a la mise en train machine automatique cellophane \u2014 Auto cellophane machine makeready man.1.13 1.07 Filcur, machine automatique cellophane \u2014 Feder, auto, cellophane machine.\u2022.0.88 0.84 Mécanicien de guillotine, 1ère classe \u2014 Cutter on knife, 1st class.1.08 103 Mécanicien de guillotine, 2e classe \u2014 Cutter on knife, 2nd class.0.97 0.92 Mécanicien dc machine à transporter et empiler motorisée \u2014 Power stacker-lift truck operator.0.91 0.86 Pressier, presse cylindre à découper \u2014 Cylinder box pressman.1.08 103 Fileui, presse cylindre à découper \u2014 Feeder, cylinder box press.0.88 0.84 Pressier, presse plateau à découper \u2014 Platen die cutting pressman.1.00 0.95 Fileur presse plateau à découper \u2014 Feeder, platen die cutting press.H 88 0.84 Eplucheur \u2014Stripper.0.84 0.80 Presseur de rebuts \u2014 Bale press operator.0.87 0.83 Préposé à l'emballage et ficelage\u2022\u2014 Packer and trier.0.80 0.76 Mécanicien sur machines non classifiées plus haut \u2014 Operator on machines not classified above.0.86 0.S2 Général \u2014 General: Electricien \u2014 Electrician.».\u201e.1 08 1 ¦ 03 Machiniste, 1ère classe \u2014 Machinist,' 1st class.1.08 1.03 Préposé à l'entretien et réparation \u2014 Maintenance & repair man.0.93 0.88 Expéditeur \u2014 Shipper.1.03 0.98 Assistant expéditeur \u2014 Ass't shipper.0.86 0.S2 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.0.93 0.88 Surveillant \u2014 Watchman.0.80 0.76 Chauffeur de bouilloires \u2014 Boiler fireman.0.83 0.79 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8A, No.17 1109 Chef-mécanicien \u2014 Chief-cngineman: par semaine per week 2e classe \u2014 2nd class.$49.59 $47.11 3e classe \u2014 3rd class.42.46 40.34 par heure ver hours Mécanicien de machine fixes \u2014 Stationary engineman.0.89 0.85 e) Echelle de base \u2014 Salariés: e) Be asiWage Scale \u2014 Male emvloyees: 1.L'échelle de base des salariés est la suivante 1.The basic wage scale of male employees pour les employés de 18 ans et plus.: being 18 years of age or over shall be as follows: Premier trois (3) mois \u2014 First three (3) months.0.60 0.57 Deuxième trois (3) mois \u2014 Second three (3) months.0.65 0.62 Troisième trois (3) mois \u2014 Third three (3) months.0.70 0.66 Quatrième trois (3) mois \u2014 Fouth three (3) months.0.75 0.71 2.L'échelle de base des salariés de moins de 18 2.The basic wage scale of male employees un-ans est la suivante: der 18 years of age shall be as follows: Premier trois (3) mois \u2014 First three (3) months.0.50 0.47 Deuxième trois (3) mois \u2014 Second three (3) months.0.55 0.52 Troisième trois (3) mois \u2014 Third three (3) months.0.60 0.57 Le nombre d'employés masculins n'ayant pas The number of male employees under 18 years 18 ans et rémunérés sous cet article ne doit pas of age and remunerated under their sction shall dépasser 10% du nombre total des salariés au not exceed 10% of the total number of the em-travail, ployees at work.Nonobstant les dispositions des alinéas précé- Notwithstanding the provisions dflfthe above dents, tout salarié n'ayant pas 18 ans et travail- paragraphs, any male employee under 18 years of lant à une opération classifiée ne doit pas recevoir age and working at a classified operation shall moins que le taux de salaire minimum de cette not receive less than the minimum wage rate of opération, sujet à la clause d'apprentissage.the said operation, subject to the apprenticeship clause.3.Le temps de service acquis par chacun des 3.The period of service of employees at the salariés au moment de l'entrée en vigueur du pré- date of the coming into force of the present de-sent décret doit être pris en considération pour crée shall be taken in consideration to deter-déterminer son salaire en regard de l'échelle de mine their wages in relation to the above basic base ci-lmut mentionnée.scale./) Apprentissage \u2014 Salariés: f) Apprenticeship \u2014 Male employees: Premier semestre: 20% de moins que le mini- First six (6) months: 20% less than minimum mum.rate.Deuxième semestre: 10% de moins que le mi- Second six (6) months: 10% less than mini- nrmum.mum rate.Le nombre des apprentis ne doit pas dépasser The number of male apprentices shall not ex-20% du nombre total des salariés au travail pour ceed 20% of the total number of male employees les opérations classifiées ci-haut mentionnées ex- engaged on the above classified operations, excepté pour les chauffeurs de bouilloires et les mé- cept stokers and stationary enginemen.caniciens de machines fixes.Notwithstanding the provisions of the present Nonobstant les dispositions de cet article, au- section, no male apprentice shall receive a remu- cun apprenti ne doit recevoir une rémunération neration less than the basic wage rateto which inférieure au taux établi par l'échelle de base au- he is normally entiled.The basic wage rate quel il a normalement droit.Le taux établi par shall prevail at all times, l'échelle de base a préséance en tout temps.g) Various operations: g) Opérations différentes: An employee wdio regularly performs, during Un salarié occupé au cours de la semaine, mais the week, various operations for which différents de façon régulière, à divers travaux pour lesquelles hourly rates are specified in the decree, shall be des taux horaires différents sont spécifiés dans le considered as belonging to that category of em- décret, est considéré comme appartenant à la ployees receiving the highest rate of pay, and catégorie des salariés les mieux rémunérés et doit paid accordingly, être payé au tarif de cette catégorie.Cependant, lorsque par exception un salarié However, should an employee be called occa-au cours d'une semaine est appelé à faire un tra- sionnally during one week, to perform an opera-vail autre que celui de son emploi régulier et clas- tion other than his regular work and classified in sifié dans une catégorie différente à un taux supé- a different category for which a higher rate than rieur à la sienne, il doit être payé à ce taux supé- his is established, he shall receive such higher rieur pour le temps seulement qu'il a fait dans rate only for the time worked in the said occa-cette occupation occasionnelle.\" sional occupation.\" 3° Les mots suivants sont ajoutés à l'article 3.The following words are added to Sec- IV, immédiatement après le titre \"IV \u2014 Heures tion IV, immediately after the title \"IV.Hours of de travail\"; \"Zone I et II\".Work\", \"Zone I and II\".4° L'article V est radié et remplacé par le sui- 4.Section V is deleted and replaced by the vant: following: \"V.Jours de fetes chômées: Zones I et II.Tout \"V.Observed holidays in Zone I and II: All travail exécuté durant les jours de fête ci-après work performed during the hereafter mentioned mentionnés doit être rémunéré au taux de salaire holidays must be paid double time, double.- a) In the French shops: New Years' Day, a) Dans les ateliers français: Le Premier de Epiphany, Ascension Day, St.John de Baptist l'An, l'Epiphanie, l'Ascension, la St-Jean-Bap- day, Labour Day, All Saints' Day, Immaculate tiste, la fête du Travail, la Toussaint, l'lmma- Conception Day and Christmas Day.culée-Conception et la Noël. 1110 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 b) Dans les ateliers anglais: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, le 24 mai, la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Actions de Grâces et la Noël.c) Le Premier de l'An.la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Travail et la Noël sont payés en plus d'être chômés lorsque ces jours de fête tombent ou sont observés un jour régulier de travail.Cependant, tout employeur accordant cinq (5) fêtes légales payés ou plus par année à ses salariés, n'est pas sujet aux dispositions de l'alinéa précédent.Les établissements qui n'observent pas la St-Jean-Baptiste, peuvent substituer cette fête payée par la Confédération.Chaque salarié doit être rémunéré pour ces jours de fête au taux des heures régulières de travail pour le nombre d'heures de travail qu'il aurait normalement fait ce jour là' Pour avoir droit à cette rémunération, le salarié doit travailler ou être prêt à travailler la journée de travail qui précède et qui suit le jour où la fête eat observée.d) L'obligation de payer salaire double pour tout travail exécuté durant les jours de fêtes ci-haut mentionnés ne s'applique pas aux gardiens, chauffeurs de bouilloires (stokers) et mécaniciens de machines fixes, ainsi qu'aux employés préposés à la réparation des machines et des immeubles.\" 5.L'article VI est radié et remplacé par le suivant: \"VI.Travail d'imprimerie: Zones I et II: Pour les fins d'application du présent décret, le travail d'imprimerie désigne et comprend toute personne employée à produire des imprimés dans les ateliers manufacturant des boites de carton.Les conditions de travail de ces salariés sont les mêmes que celles déterminées dans tous les autres articles du présent décret, sujettes cependant aux modifications ou aux additions prévues au présent article comme dispositons spéciales suivantes: a) Définitions: 1.Le mot \"compagnon\" désigne un salarié qui a été en apprentisage durant le nombre d'années déterminé au paragraphe \"h\" du présent article.2.Le mot \"apprenti\" désigne un salarié qui apprend le travail exécuté par un compagnon.Le r.ombre d'années d'apprentissage est tel que mentionné au paragraphe \"h\" du présent article.3.Les mots \"margeur\" ou \"préposé au margeur automatique\" désigent tout salarié qui marge à la main ou qui est préposé au fonctionnement du mécanisme qui aliment les presses typographiques.4.Le mot \"aide\" désigne un salarié inexpérimenté du sexe masculin effectuant des travaux manuels ne nécessitant aucune formation spéciale.b) Semaine de travail: La semaine régulière de travail est de quarante-cinq (45) heures réparties en périodes n'excédant pas neuf (9) heures de travail par équipe du lundi au vendredi inclusivement.c) Surtemps: 1.Tout travail exécuté par un salarié avant ou après les heures régulières de son équipe est considéré comme du travail supplémentaire et rémunéré au taux et demi pour les (3) premières heures supplémentaires et au taux double pour les heures subséquentes.2.Lorsqu'un salarié travaille sur des équipes différentes dans une même période de vingt-quatre (24) heures, il est considéré comme appartenant à la première équipe avec laquelle il a travaillé et tout travail exécuté après les heures régulières de cette première équipe est considéré comme du temps supplémentaire.b) In the English shops: New Year's Day, Good Friday, the 24th of May, Confederation Day, Labour Day, Thanksgiving Day and Christmas Day.c) New Year's Day, St.John the Baptist Day, Labour Day and Christmas Day shall bo paid in addition to being observed, provided these holidays fall or observed on a regular working day.However, an employer who grants five (5) or more legal holidays with pay per year to his employees is not subject to the foregoing paragraph.Establishments not observing the St.John the Baptist Day may substitute the Confederation Day for this paid holiday.Each employee shall be paid for these holidays at straight time rates for the number of hours that would normally have been worked.To qualify for such holiday pay as aforesaid, an employee must work or stand ready to work the regular work day preceding and following the day on which the holiday is kept.d) The obligation to pay double time for all work performed during the above mentioned holidays shall neither apply to watchmen, firemen (stokers) and stationary enginemen nor to repair men on machines and buildings.5.Section VI is deleted and replaced by the following: VI.Printing Work \u2014 Zone I and II: For the purposes of the present decree, printing employees designate and comprise all persons engaged in the production of printing in plants manufacturing paper boxes.The working conditions of theses employees shall be the same as those set out in all the other sections of this decree with, however, the following modifications and supplemental changes: a) Definitions: 1.The word \"journeyman\" means an employee wdio has completed the term of apprenticeship as set forth in subsection \"h\" of the present section.2.The word \"apprentice\" means an employee who is learning a journeyman's trade.The number of years of his or her apprenticeship shall be as set forth in subsection \"h\" of the present section.3.The words \"feeder\" or \"feeder operator\" mean any employee who manually feeds stock to \"letter press\" presses or who tends the paper feeding mechanism of such presses.4.The word \"helper\" means an unskilled male employee engaged on work not requiring previous experience or training.b) Hour week: The regular work week shall consist of forty-five (45) hours divided into periods not exceeding nine (9) hours per shift from Monday to Friday inclusively.c) Overtime: 1.Overtime shall be all time worked by any employee before or after the regular hours of his shift and shall be paid ar the rate of time and a half for the first three (3) hours, and at the rate of double time thereafter.2.If an employee works on more than one shift within any twenty-four (24) hour period, he shall be {deemed to belong to the first shift on which he worked, and any time he works after the regular quitting time of the first shift shall be deemed to be overtime. QXjEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April, 26th 1952, Vol.81, No.17 \u2022 1111 d) Jours de fetes payés: 1.Les jours de fêtes suivants sont des jours de fêtes payés: i) Dans les ateliers français: Le Premier de l'An, l'Epiphanie, la fête du Travail, la Toussaint, rimmaculée-Conccption, la St-Jean-Baptiste et le jour de Noël.ii) Dans les ateliers anglais: Le Premier de l'An, le Vendredi Saint, le 24 mai, la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Actions de Grâces et le jour de Noël.2.Lorsqu'un jour de fête tombe ou est observé un jour régulier de travail et qu'aucun travail n'est exécuté ce jour-là, les salariés doivent être payés aux taux des heures régulières de travail pour le nombre d'heures dc travail qu'ils auraient faites ce jour-là.(Tout travail exécuté l'un de ces jours de fête doit être rémunéré à un taux double dc salaire tel que prévu à l'article V).3.Pour avoir droit à la rémunération ci-haut prévue pour les jours de fêtes payés, le salarié doit, a moins qu'il ne soit malade ou excusé par l'employeur, travailler ou être prêt à travailler la journée de travail qui précède et celle qui suit le jour où la fête est observée.c) Apprentissage: 1.Le nombre maximun d'apprentis alloué à chaque équipe pour chaque département, tant pour le temps régulier que pour le temps supplémentaire est le suivant: Pour 1, 2 ou 3 compagnons (employés régulièrement).1 apprenti Pour 4, 5 ou 6 compagnons (employés régulièrement).2 apprentis Pour 7, 8 ou 9 compagnons (employés régulièrement.3 apprentis Pour chaque groupe de trois (3) compagnons additionnels, (employés régulièrement).1 apprenti 2.Dans aucun cas, les apprentis et ou les margeurs ne peuvent travailler hors la présence d'un compagnon.3.Un apprenti de première année peut être ajouté au personnel du département lorsqu'un apprenti déjà régulièrement employé dans ce département entre dans sa quatrième (4) année d'apprentissage.4.Les assistants-pressiers, les margeurs et les aides n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination du nombre d'apprentis./) Fonctionnement des presses: Les conditions régissent le fonctionnement de l'atelier d'impression sont comme suit: 1.Pour toutes les presses à plateau et les petites presses automatiques (automatic job presses), pas moins d'un compagnon pressier pour les trois (3) premières presses en opération ou fraction d'icelles, et un compagnon pressier additionnel pour chaque trois (3) presses additionnelles en opération ou fraction d'icelles.Les autres salariés employés sur ces presses peuvent être des assistants-pressiers, des margeurs ou des apprentis \u2014 ces derniers étant assujettis, quant à leur nombre au paragraphe \"e\" du présent article.2.Pour toutes les presses cylindriques à l'exception des petites presses automatiques (automatic job presses), pas moins d'un compagnon pressier pour les deux (2) premières presses en opération ou fraction d'icelle, et un (1) compagnon pressier additionnel pour chaque deux (2) presses additionnelles en opération ou fraction d'icelles.Les autres salariés employés sur ces presses peuvent être des assistants-pressiers, des margeurs ou des apprentis, ces derniers étant assujettis, quant à leur nombre au paragraphe \"e\" du présent article.3.Pour toutes les presses cylindriques à deux couleurs et plus, soit automatiques ou margées d) Holidays zoith vay: 1.The following days shall be kept as holidays with pay: i) In French plants: New Year's Day, Epiphany, Labour Day, All Saints' Day, Immaculate Conception Day, St.John the Baptist Day and Christmas Day.ii.In English, vlants: New Year's Day, Good Friday, May 24, Confederation Day, Labour Day, Thanksgiving Day and Christmas Day.2.If a day observed as a holiday occurs or is kept on a regularly scheduled work day, employees shall be paid for such holiday, when not worked, at straight time rates for the number of hours that would normally have been worked.(When worked, double time rates shall prevail, as provided for in Section V).3.To qualify for holiday pay as aforesaid, an employee must, unless ill or excused by the management, work or stand ready to work the regular work day preceding and the regular work day following the day on which the holiday is kept.e) Apprenticeship: 1.The maximum number of apprentices allowed, for regular and overtime work, in each, department, on each shift, shall be as follows: For 1, 2 or 3 journeyman (regularly employed) .1 apprentice For 4, 5 or 6 journeyman (regularly employed) .2 apprentices For 7, 8 or 9 journeyman (regularly employed) .3 apprentices For each 3 additional journeymen (regularly employed).1 apprentice 2.In no case shall apprentices and/or feeders be permitted to work unless there is a journeyman present.3.A first year apprentice may be added to the department when a n apprentice actually employed in the said department enters his fourth year.4.Assistant-pressmen, feeders and helpers shall no be included in reckoning the number of apprentices./) Operation of presses: The rules governing the operation of presses shall be as follows: 1.For all platen presses and automatic job presses, not less than one journeyman pressman, for the first three (3) presses or fraction thereof in operation, and one additional journeyman pressman for each three (3) additional presses or fraction thereof in operation, shall be employed, other employees engaged on such presses may be assistant pressmen, feeders or apprentices \u2014 the last named being subject, in respect of numbers, to sub-section \"e\" of the present section.2.For all cylinder presses (excluding automatic job presses), not less than one journeyman presseman for the first two (2) presses or fraction thereof in operation, and one (1) additional journeyman pressman for every two (2) additional presses or fraction thereof in operation, shall be employed.Other employees engaged on such presses may be assistant-pressmen, feeders or apprentices \u2014 the last named being subject, in respect of numbers, to sub-section \"e\" of the present section.3.For all multicolour cylinder presses \u2014 whether automatic or hand fed \u2014 not less than 1112 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 8A, N° 17 à la main, pas moins d'un compagnon pressier one (1) journeyman pressman for each press in pour chaque presse en opération.Les autres operation shall be employed.Other employees salariés employés sur ces presses peuvent être engaged on such presses may be assistant-press-des assistants-pressiers, des margeurs ou des ap- men, feeders or apprentices \u2014 the last named prentis \u2014 ces derniers étant assujettis, quant à being subject, in respect of numbers, to subleur nombre au paragraphe \"e\" du présent section \"e\" of the present section, article.g) Vacances- payées: 1.Tout salarié, qui, au g) Vacation with pay: 1.An employee who, 1er mai de chaque année a été quatre (4) mois ou on the first of May of each year, has been four plus au service du même employeur a drpit, dans (4) months or more in the service of the same la période annuelle s'étendant du 1er mai au 1er employer shall be entiled between the first of octobre, à des vacances payées continués d'une May and the- first of October, to a continuous durée égale à autant de demi-journées qu'il a de vacation with pay equal in duration to one half-mois de service avec ledit employeur, et ce, jus- day for each month of service for the employer up qu'a concurrence d'une semaine complète.Il to one complete working week.He shall re-doit recevoir pour sa période de vacances un mon- ccive for bis vacation the amount he would have tant d'argent égal à celui qu'il autait reçu s'il received had he worked, avait travaillé.2.Tout salarié qui compte au 1er mai dc cha- 2.An employee who, on May 1st, of any year, que année deux (2) ans dc service ou plus avec le has had two or more year's service with the même employeur, a droit au cours de ladite an- same employer shall be entiled to a vacation née à des vacances payées comme suit: with pay, in that year, as follows: 2 ans de service: 7 jours de vacances.2 years'service: 7 days vacation 3 ans de service: S jour de vacances.3 years'service: 8 days vacation 4 ans de service: 9 jours de vacances.4 years'service: 9 days vacation 5 ans dc service: 10 jours de vacances.5 years'service: 10 days vacation Dans le cas où un salarié a droit au cours d'une In the case where an employee is entitled in année, à un ou plusieurs jours -additionnels de any year to one or more additional days' vacation vacances en vertu du présent paragraphe, il est in virtue of this sub-section, it will be left to the laissé à la discrétion de l'employeur, après avoir discretion of the employer, after notification by pris avis du salarié, de déterminer à quelle date the employee, to determine when such additional ce ou ces jours additionnels de vacances seront day or days of vacation shall be taken during the pris au cours de ladite année.course of the said year.3.Si un jour de fête prévu au paragraphe \"d\" 3.Should one of the statutory holidays provi-du présent article ou un jour observé comme tel (led for in subsection \"d\" of the present section, survient durant la période dc vacances d'un salarié, or a day kept as such fall during an employee's une journée additionnelle dc vacances doit être vacation period an additional day's vacation shall accordée au salarié à une date que l'employeur be granted at a time mutually agreed upon et le salarié détermineront ensemble, ou un mon- between employer and employee, or the equiva-tant d'argent équi.aient pour y tenir lieu doit lent in pay in lieu thereof.lui être accordé.Taux horaires minima Minimum hourly rates h) Taux minima \u2014 Minimum rates: Zones Atelier dc composition \u2014 Composing room: I II Compagnon typographe \u2014 Journeyman Compositor.S 1.60 8 1.32 Presses à plateau \u2014 Platen presses: Compagnon pressier \u2014 Journeyman pressman.1.32 1.10 Margeurs sur presses ci-dessus \u2014 Feeders.1.07 0.88 Presses cylindriques (une couleur) \u2014 Cylinder Presses (one colour): Compagnon pressier \u2014 Journeyman pressman.1.60 1.32 Assistant-pressier \u2014 Assistant pressman.1.32 1.10 Margeurs sur presses ci-dessus \u2014 Feeder on above presses.1.15 0.93 Presses cylindriques (2 couleurs) \u2014 Cylinder Presses (Multicolour): Compagnon pressier \u2014 Journeyman pressman.1.77 1.38 Assistant pressier ou margeur sur presses ci-dessus \u2014 Assistant pressman or feeder on above presses.1.38 l.00 Apprenti-masculin \u2014 Apprentice-Male: 1ère année \u2014 1er semestre \u20141st year \u20141st six months.0.65 0.62 \u2014 2e semestre \u2014 2nd six months.0.75 0.71 2e année \u20141er semestre \u2014 2nd year\u20141st six months.0.85 0.81 \u2014 2e semestre \u2014 2nd six months.0.95 0.90 3e année \u20141er semestre \u2014 3rd year\u20141st six months.1.05 1.00 \u2014 2e semestre \u2014 2nd six months.1.15 1.09 4e année \u20141er semestre \u2014 4th year\u20141st six months.1.25 1.19 \u2014 2e semestre \u2014 \u2014 2nd six months.1.35 1.28 Aide inexpérimenté (masculin) \u2014 Helper (male) unskilled 1ère année \u2014 1er semestre \u2014 1st year \u2014 1st six months.0.65 0.62 Subséquemment \u2014 Thereafter.0.75 0.71 6° Les paragraphes \"a\" et \"h\" de l'article 6) Sub-sections \"a\" and \"h\" of Section VII VU sont radiés et remplacés par les suivants: are deleted sand replaced by the following: \"VTI.Clauses générales \u2014 Zones I et II: VD \u2014 General Provisions \u2014 Zone I and II: a) Vacances payées: 1.Tout salarié, qui, au a) Vacation with pay: 1.An employee who, on 1er mai de chaque année a été quatre (4) mois ou the first of May of each year, has been four (4) plus au service du même employeur a droit, dans months or more at the service of the same em-la période annuelle s'étendant du 1er mai au 1er ployer shall be entitled between the first of May octobre, à des vacances payées continues d'une and the first of October, to a continuous vaca- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1113 durée égale à autant de demi-journées qu'il a de mois de service avec ledit employeur, et ce, jusqu'à concurrence d'une semaine complète.Il doit recevoir pour sa période de vacances un montant d'argent égal à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé.2.Tout salarié, qui, au 1er mai de chaque année, a été cinq années ou plus au service du même employeur a droit à deux semaines de vacances payées, durant la période s'étendant du 1er mai au 1er octobre de la même année.Il doit recevoir pour ladite période de vacances en montant d'argent égal à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé.3.Un salarié qui a droit à des vacances selon les conditions sus-mentionnées, mais qui cesse de travailler pour ledit employeur avant dc prendre ses vacances doit recevoir pour ses vacances, le salaire auquel il a droit mais qu'il n'a pas reçu.\" \"h) Carte de service: Le Comité paritaire émettra une carte de service à tout salarié exécutant une opération classifiée au décret.Pour être eligible à ladite carte, un salarié doit avoir été au service du même employeur pour une période d'au moins une année.Le temps de service acquis par un salarié sur une opération classifiée est permanent et est enregistré sur cette carte.Le temps ainsi acquis est déductible sur la période d'apprentissage requise par le décret pour une même opération.Un salarié doit recevoir au moins le taux de salaire minimum dc l'opération classifiée qu'il a exécutée si ce dernier présente à son employeur, au moment de son engagement, une carte de service indiquant une période de temps supérieur pour ladite opération à celle requise par la clause d'apprentissage.\" 7° Les articles VIII et VIII-A son radiés.(Document \"F\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 32424-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 412 Québec le 17 avril 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Section \"D\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuilles.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuilles, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 540-B du 30 mai 1951, soit prolongé jusqu'au 5 juillet 1952, aux mêmes taux et conditions.A.MORISSET, 32424-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 412 Québec, le 17 avril 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Section \"G\" Concernant la prolongation du décret relatif à la tion with pay equal in duration to one half-day for each month of service for the employer up to one complete working week.He shall receive for his vacation the amount he would have received had he worked.2.An employee, who on the first of May of each year, has had five (5) years or more service with the same employer, shall be entitle 1 to receive two working weeks vacation with pay between the first of May and the first of October of the same year.He shall receive for this vacation the amount he would have received had he worked.3.An employee who is entitled to the above vacation but wdio ceases to work for the employer before taking the vacation shall receive the wages for the vacation to which he is entitled but which he did not receive.h) Service Cdrd: The Joint Committee will issue a service card to any employee performing an operation classified in the Decree.To be eligible to this card, an employee must have been at the service of the same employer for a period of not less than one year.The period of service acquired by an employee on a classified operation, is permanent and is registered on this card.The period of service so acquired with is deductible from the apprenticeship .period required on the same operation.An employee shall receive not less than the minimum wage rate of the classified operation he is performing if he furnishes his employer upon being hiredwith a service card showing a longer period of service on the said operation than the one required by the apprenticeship clause.7) Sections VIII and VHI-A arc deleted.(Document \"F\" annexed to the order) A.MORISSET, 32424-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 412 Quebec, April 17, 1952.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"D\" Concerning an extension of the right to levy of the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry in the district of Montreal.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Ministei of Labour, That the right to levy of the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry, authorized by a By-law approved by Order in Council number 540-B of May 30, 1951, be extended until July 5, 1952, with the same rate and conditions.A.MORISSET, 32424-0 Uerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 412 Quebec, April 17, 1952.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"G\" Concerning an extension of the decree ralating 1114 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 81, N9 17 fabrication des produits de métal en feuille dans la région de Montréal.Il est ordonne, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le décret numéro 456 du 26 avril 1951, amendé par les arrêtés en conseil numéros 829-B, 1196-C et 1431-E des 1er août, 25 octobre et 20 décembre 1951, relatif à l'industrie de la fabrication du métal en feuille dans l'Ile de Montréal et un rayon de quinze (15) milles de ses limites, soit prolongé jusqu'au 5 juillet 1952.(Document \"G\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 32424-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 369 Quebec, le 9 avril 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant \"La Semaine de l'arbre\".Attendu que la forêt est une des plus importantes richesses de la pr vvince; Attendu Qu'il importe d'en assurer la conservation et la restauration, par tous les moyens possibles; ' Attendu que ceci ne peut se réaliser que dans la mesure où la population a une mentalité vraiment forestière; Attendu que cette mentalité est la base du culte de l'arbre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'Honorable Ministre des Terres et Forêts:\u2014 Qu'une semaine doit nommément être consacrée au culte de l'arbre et que la période du 4 au 11 mai 1952 soit déclarée la \"Semaine de l'Arbre\" dans la Province de Québec.A.MORISSET, 32423-o Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers Province de Québec Municipalité du Village du Bassin de Chambly Comté de Chambly Avis public par les soussignés, que dans le mois suivant le trois mai prochain, le conseil municipal présentera une requête au Lieutenant-Gouverneur en conseil, le priant d'ériger le territoire actuel du village du Bassin de Chambly, dans le comté de Chambly, en municipalité de ville sous le nom de \"Ville de Chambly.\" (Town of Chambly), sous l'empire de la Loi des cités et villes (S.R.Q.de 1941, chap.233); et que le chiffre de la population permanente dudirvillage est de 2,275, d'après un recensement spécial fait sur l'ordre du conseil, conformément à l'article 12 de ladite loi.Chambly Bassin, Que.le 7 avril 1952.Maire.LÉO LAREAU, N.P.Secrétaire-trésorier, 32358-15-4-0 GÉRARD BLAIN.to the Sheet Metal Fabricating Industry in the district of Montreal.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the decree number 456 of April 26, 1951.as amended by Orders 829-B, 1196-C and 1431-E of August 1, October 25 and December 20, 1951, relating to the Sheet Metal Fabricating Industry in the Island of Montreal and a radius of fifteenth (15) miles from its limits, be extended until July 5, 1952.Document \"G\" annexed to the Order).A.MORISSET, 32424-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 369 Quebec, April 9, 1952.Present: The Lieutenant-Govcrnor-in-Council.Concerning \"Arbor Week\".Whereas the forest is one of the most important resources of the Province; Whereas it is important that conservation and its restoration be assured by all possible means; Whereas this can only be realized insofar as the public is truly forestry-minded; Whereas this mental attitude is the basis for the love and care of trees; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Lands and Forests:\u2014 That a week be especially dedicated to implant in the public mind the love of trees and that the period from the 4th to the 11th of May, 1952, be declared \"Arbor Week\" in the Province of Quebec.A.MORISSET, 32423 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices Province of Quebec Municipality of Village du Bassin de Chambly County of Chambly Public notice by the undersigned, that during the month following the third day of may next, the town council will submit a requisition to the Lieutenant-Governor in council, applying for the erection of the actual territory known as Municipalité du Village du Bassin de Chambly, in the county of Chambly, into a town municipality to be known as \"Town of Chambly\" (Ville de Chambly); under the provisions of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1941, chapter 233); and that the permanent population of the said village is 2,275 according to a special census ordered by the council, in accordance with article 12 of the said Act.Chambly Bassin, Que.April 7th., 1952.LÉO LAREAU.N.P.Mayor.GÉRARD BLAIN, 32358-15-4-0 Secretarj'-treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1052, Vol.8L, No.17 1115 Avis est par les présentes donné, que conformément à la loi du régime des Eaux Courantes, \"Les Industries de Pulpe de Val-Barrette Ltée\", compagnie incorporée ayant sa principale place d'affaires à VaUBarrette, Comté de Labelle, P.Q., propriétaire d'un terrain situé sur la rive Est de la rivière Kiamika et du bail cmphy-théotique consenti par la Province dc Québec à David Galbraithe et passé devant Edouard Hamel, notaire, le cinq juillet mil neuf cent treize, demande au Lieutenant-gouverneur en Conseil, la permission dc construire, de maintenir et d'exploiter un barrage en béton et une centrale hydro-électrique à l'endroit du vieux barrage en bois situé sur la première chute, dite \"Chute Renaud\", sur la rivière Kiamika en front des lots 11 et 12, rang J, canton Campbell, Comté de Labelle.Les originaux des plans et devis ont été déposés au Département des Ressources Hydrauliques de la Province de Québec et copie des dits plans et devis a été déposée au bureau de la division d'enregistrement du Comté dc Labelle à Mont Laurier.La demande contenue dans cette requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle.Québec ce 8 avril 1952.L'Ingénieur Conseil, 32368-15-4-0 ZACHÉE LANG LAIS.Notice is hereby given, that, pursuant to the Water-Course Act, the company, \"Les Industries de Pulpe de Val-Barrette Ltée\", duly incorpoated and having its head office at Val-Barrette, county of Labelle, P.Q., proprietor of a lot of land situate on the east bank of the Kiamika river and of the emphyteutic lease consented by the Province of Quebec to David Galbraithe and passed before Edouard Hamel, notary, on the fifth of July, one thousand nine hundred and thirteen, applies to the Lieutenant-Governor in Council for leave to build, maintain and operate a concrete dam and a hydro-electric power-house at the site of the old wooden dam situate on the first falls, called \"Chute Renaud\", on the Kiamika river in front of lots 11 and 12, range J, Township Campbell, County of Labelle.The originals of the plans and specifications have been filed in the Department of Hydraulic Resources of the Province of Quebec, and a copy of said plans and specifications has been filed in the office of the Registration Division of the County of Labelle at Mont-Laurier.The application contained in the said petition will be taken into consideration on or after the day following the date of the last publication of the present notice in the Official Gazette.Quebec, April S, 1952.Z AC II EE LANGEAIS, 32308-15-4 Consulting Engineer.Règlement N° 26 Qu'il soit résolu que l'actif de la compagnie soit partagé au pro rata entre les actionnaires de la compagnie.Montréal, le 16 avril 1952.(sgd) N.L.RAPPAPORT, L'Avocat dc la Clinton Realties 32426-o Incorporated.Northern Canada Supply (quebec) Limited Règlement N° 86 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de Northern Canada Supply (Quebec) Limited (ci-après nommée la compagnie) ce qui suit: 1.Que le nombre des membres du bureau de direction de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de cinq (5) à trois (3).2.Que le quorum du bureau de direction soit et il est, par les présentes, fixé à deux (2).3.Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés, pour se conformer au précédent.Décrété ce 20e jour de mars 1952.Témoin: Le se au corporatif dc la compagnie.(Sceau) Le Président, (Signé) D.E.JEMMETT.Le Secrétaire, 32427 (Signé) JNO.F.JEMMETT.Seneca Weavers Limited Règlement N° 22 Il a été résolu que la distribution de l'actif de la compagnie soit faite au pro rata entre les actionnaires.Montréal, le 18 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, 32428 EDNA MOSCOVITCH.By-Law No.26 Be it resolved that the assets of the Company be divided rateably among the shareholders of the Company.Montreal, April 16, 1952.(sgd) N.L.RAPPAPORT, Attorney for Clinton Realties 32426-o Incorporated.Northern Canada Supply (quebec) Limited By-Law No.36 Be it enacted and it is hereby enacted as a Bylaw of Northern Canada Supply (Quebec) Limited, (hereinafter called the Company), as follows: 1.The number of the Board of Directors of the Company be and is hereby decreased from five (5) to three (3).2.The quorum of the Board of Directors be and is hereby fixed as two (2).3.The By-laws of the Company be and the same arc hereby amended to accord with the foregoing.Enacted this 20th day of March, 1952.Witness the Corporate Seal of the Company.(Seal) (Sgnd) D.E.JEMMETT, President.(Sgnd) JNO.F.JEMMETT.32427-0 Secretary.Seneca Weavers Limited By-Law No.22 Resolved that distribution of the assets of the Company be made Pro rata to the Shareholders.Montreal, April 18th, 1952.EDNA MOSCOVITCH, 32428-o Secretary-Treasurer. 1116 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 8A, N° 17 Canada, Province de Québec, district de Montréal BonTitiTE Apartments Limited Il a été résolu que la distribution dc l'actif dc la compagnie soit faite au prorata entre les actionnaires.Montréal, le 2 janvier, 1952.Le Secrétaire, 32429-0 IRVING SIIAPERA.Canada, province dc Québec, district de Montréal Bortrite Apartments Limited Avis est par les présentes donné que Bortrite Apartments Limited demandera la permission d'abandonner sa charte conformément à la Loi des Compagnies de Québec.Montréal, le 9 avril 1952.Le Secrétaire.32430 IRVING SHAPERA.Canada, Province of Quebec, District of Montreal Bortrite Apartments Limited Resolved that distribution of the assets of the Company be made pro rata to the shareholders.Montreal, Januarv 2nd, 1952.IRVING SHAPERA, 32429-o Secretary.Canada, province of Quebec, district of Montreal Bortrite Apartments Limited Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies' Act, Bortrite Apartments Limited will make application for leave to surrender its Charter.Montreal, April 9th, 1952.irving shapera; 32430-o Secretary.Popular Jobbers Inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Popular Jobbers Inc.\".une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, disposera dc ses biens, distribuera son actif au prorata entre ses actionnaires et s'adressera subséquemment au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies dc Québec.Montréal, 17 avril 1952.Le Procureur de la requérante, 32442 EDWARD G.TANNAGE.Popular Jobbers Inc.Notice is hereby given that \"Popular Jobbers Inc.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will dispose of its property, distribute its assets rateably among its shareholders and subsequently wdll apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, April 17th, 1952.EDWARD G.TANNAGE, 32442-o Attorney for the Petitioner.Avis est donné que, sur la recommandation de PÀssistant-procureur général, l'honorable Secrétaire dc la Province a approuvé le 17 avril 1952, les règlements 1 à 13 inclusivement de \"Association des Chirurgiens de la Province dc Québec\" \u2014 \"Association of Surgeons of the Province of Quebec,\" tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 20 février 1952.et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 dc la Loi des compagnies de Québec.(S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 18 avril 1952.Le Sous-secrétaire dc la Province.32450-o JEAN BRUCHÉSI.Globe Paper Box Co.Limited Règlement N° 28 Attendu qu'il est jugé nécessaire de diminuer le nombre des directeurs de la compagnie de quatre à trois; En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie: Que le nombre des directeurs de la compagnie soit changé en diminuant le nombre des dits directeurs de quatre à trois.' Et, que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Daté de ce dix-septième jour de mars, mil neuf cent cinquante-deux.Le Secrétaire, 32451 DANIEL WAINBERG.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, bylaws 1 to 13 inclusively of the \"Association des Chirurgiens dc la Province de Québec\" \u2014 \"Association of Surgeons of the Province of Quebec\" as adopted at the meeting held on February 20, 1952, has been approved by the Honourable the Provincial Secretary on April 17, 1952, and the same, pursuant to the provisions of section 225.of the Quebec Companies' Act, (R.S.Q.1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary.April 18, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32450 Under Secretary of the Province.Globe Paper Box Co.Limited By-law No.2S Whereas it is expedient to decrease the number of directors of the company from four to three; Now therefore be it enacted as a by-law of the company: That the number of directors of the company be varied by decreasing the number of such directors from four to three.And that By-laws of the company be and they are hereby amended to accord with the foregoing.Dated this seventeenth day of March, one thousand nine hundred and fifty-two.DANIEL WAINBERG, 32451-0 Secretary.i QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8k, No.17 1117 Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire dc la Province a approuvé le 17 avril 1952, les règlements généraux de \"L'Association des Chemins d'Hiver dc St-Adricn dc Ham\", tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 8 mars 1952, et ce, conformément aux dispositions dc l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec, (S.ll.Q.1911, chapitre 276).lionne au bureau du Secrétaire de la Province, le 17 avril 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32452-Q JEAN\" BRUCHÉSI.Paul Collet & Co.Ltd.Paul Collet & Cie Ltée Règlement N° SA (réduisant le nombre des directeurs de la compagnie de 5 à 3) 1.Le nombre des directeurs de \"Paul Collet & Co.Ltd\" - \"Paul Collet & Cie Ltée\", est par les présentes réduit de cinq (5) à trois (3).2.Le règlement N° 3 de la compagnie est amendé en conséquence.Certifié vraie copie.Le Président.32453-0 PAUL COLLET.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the general by-laws of \"L'Association des Chemins d'Hiver de St-Adrien de Ham\", as adopted at the meeting held on March 8,1952, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on April 17, 1952, and the same, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act, (R.S.Q.1941 .chapter276).Given at the office of the Provincial Secretarv, April 17, 1952.JEAN BRUCHÉSI, , 32452 Under Secretary of the Province.Paul Collet & Co.Ltd.Paul Collet & Cie Ltée Jiy-law No.3 A (Reducing the number of Directors of the company from 5 to 3) 1.The number of directors of \"Paul Collet & Co.Ltd.\" \u2014 \"Paid Collet & Cie Ltée\" is hereby reduced from five (5) to three (3).2.By-law No.3 of the company is amended accordingly.Certified true copv.PAUL COLLET, 32453 President.Stan chest Limited St an crest Limited Règlement N° B By-law No.B (Diminuant le nombre des directeurs de 4 à 3) (reducing the number of directors from 4 to 3) \"Que le nombre des directeurs de la compagnie \"That the number of directors of the company soit diminué de quatre à trois.\" be decreased from four to three\".Certifié copie conforme du règlement N° B.dé- Certified copy of By-law No.B, enacted by the crété par les directeurs le 18e jour de mars 1952 et directors on the 18th day of March, 1952,'and confirmé à l'unanimité par les actionnaires le 18c unanimously confirmed by the shareholders on jour de mars 1952.the 18th day of March, 1952.Le Secrétaire, HARRY MILLER, 32154 HARRY MILLER.32454-o Secretarv.AVIS NOTICE (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicates' Act) La formation d'une société, sous le nom de The formation of an association under the na- \"Thc Aldred Building Service Employees' Asso- me of \"The: Aid red Building Service Employees' ciation\", pour l'étude, la défense et le développe- Association\" for the study, defence and promo- ment des intérêts économiques, sociaux et mo- tion of the economic, social and moral interests raux de ses membres, a été autorisée par le Sccré- of its members, bas been authorized by the Prov- taire de la Province le 17 avril 1952.incial Secretary on April 17, 1952.Le siège social du syndicat professionnel pré- The principal place of business of the said'pro-cite est situé à 3435, rue Evelyn, Montréal, dis- fcssional syndicate is at 3435 Evelyn Street, trict judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 32455 JEAN BRUCHÉSI.32455-o Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de Notice is hereby given that, upon the recom- l'Assistant-procureur général, l'honorable Sccré- mendation of the Deputy Attorney General, the taire de la Province a approuvé le 17 avril 1952, by-laws of the \"Sept Isles Yacht Club\", as adop- les règlements de \"The Sept lies Yacht Club\", ted at the general special meeting held on April tels qu'adoptés à l'assemblée générale spéciale 23, 1951, has been approved by the Honourable tenue le 23 avril 1951, et ce, conformément aux the Provincial Secretary, on April 17, 1952, and dispositions dc l'article 225 de la Loi des compa- the same, pursuant to the provisions of section gnies de Québec.225 tne Quebec Companies' Act.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, Given at the oflice of the Provincial Secretary, le 18 avril 1952.on APril 18, 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 32456 JEAN BRUCHÉSI.32456 Under Secretary of the Province. 1118 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, NQ 17 The Glade Corporation Règlement spécial \"A\" Un règlement concernant la distribution de l'actif de la compagnie et l'abandon de sa charte.Sommaire La compagnie cessera d'exercer son commerce le 31 décembre 1951 ; à la suite de cette discontinuation, l'actif de la compagnie sera distribué entre les actionnaires et une demande sera faite afin d'obtenir l'abandon dc la charte de la compagnie.Montréal, 22 avril 1952.[Sceau] Le Secrétaire.32458 RALPH C.TEES.AVIS PUBLIC R-2 Avis est par la présente donné qu'à son assemblée régulière du 9 avril 1952, le Conseil de la ville de Roxboro a adopté une résolution décidant en principe de changer la date des élections et que dans un délai de 30 jours à compter de la dernière insertion du présent avis dans la Gazette Officielle de Québec, 1 aVille de Roxboro s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en son Conseil pour fixer au premier jour juridique de juillet la date des élections municipales.Daté à Montréal, ce 21ième jour d'avril 1952.Copie conforme.Le Secrétaire-trésorier.32466-17-4-0 JEAN FILION.Chartes \u2014 Abandon de The Glade Construction Special By-law \"A\" Being a By-law respecting the distribution of the assets of the company and the surrender of its charter.Summary The company shall cease to carry on business as at December 31, 1951; following such discontinuance the assets of the company shall be distributed amonst the shareholders and application made for the surrender of the charter of the company.Montreal, April 22, 1952.[ScalJ RALPH C.TEES, 32458-o Secretary.PUBLIC NOTICE R-3 Notice is hereby given that at its regular meeting of April the 9th, 1952, the.Council of the Town of Roxboro has adopted a resolution deciding to change the date of the Municipal elections and that at the expiration of 30 days of the last insertion of the present notice in the Quebec Official Gazette, the Town of Roxboro will petition the Honorable Lieutenant Governor in Council to fix the date of the Municipal elections on the 1st judical day of July.Dated in Montreal, this 21st, day of April 1952.True copy.JEAN FILLION, 32466-17-4-o Secretary-Treasurer.Charters \u2014 Surrender of Avis est donné par les présents que \"Dominion Sales Corporation Ltd.\", demandera la permission d'abandonner sa charte à compter d'une date à être fixé.Dominion Sales Corporation Ltd., Par le Secrétaire, R.HODGE.Les procureur de Dominion Sales Corporation Ltd Louis & Berger.32431-0 AVIS Berry Industries Limited Avis est donné que la compagnie Berry Industries' Limited, constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 19o2.Le Secrétaire, 32432 K\".HUGHES.AVIS Lntrepid Time Recorders Llmited (1940) Avis est donné que la compagnie Intrepid Time Recorders Limited (1940), constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Mont- Notice is hereby given that \"Dominion Sales Corporation Ltd.\", will apply for leave to surrender its Charter at a date to be fixed.Dominion Sales Corporation Ltd., Per: R.HODGE, Secretary.Louis & Berger, Attorneys for Dominion Sales Corporation Ltd.32431-0 NOTICE Berry Industries Limited Notice is hereby given that Berry Industries Limited, a corporation constituted under the Quebec Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this 17th day of April 1952.K.HUGHES, 32432-0 Secretary.NOTICE Intrepid Time Recorders Limited (1940) Notice is hereby given that Intrepid time Recorders Limited (1940), a corporation constituted under the Quebec Companies Act and having its head office on the City of Montreal, will apply QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8A, No.17 1119 real, s'adressera au Procureur general dc la province de Quebec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 1952.Le Secrétaire, 32433 C.FRED BERRY.Balmoral Liquors Limitée Avis est donné que la compagnie \"Balmoral Liquors Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 16 avril 1952.Les Procureurs de \"Balmoral Liquors Limitée, 32439-0 MEUNIER & HÉBERT.Laurentian Resorts Limited Avis est donné que la compagnie \"Laurentian Resorts Limited\", constituée en corporation par lettres patentes dc la province dc Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 16 avril 1952.Les Procureurs de Laurentian Resorts Limited, 32440-o MEUNIER & HÉBERT.AVIS LÉGAL Conformément à la Loi des compagnies dc Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276 et amendements), la compagnie \"Lann Specialties Ltd.\", donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera à l'Honorable Procureur général dc la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner la charte de la compagnie.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 1952.Le Secrétaire, 32441 A.J.ISAIF.AVIS LEGAL Selon les dispositions de la Loi des Compagnies de Québec \"l-ity Parcel Delivery Inc.\" par les présentes donne avis qu'elle demandera au Procureur Général la permission d'abandonner sa Charte à compter de la date qu'il déterminera.Montreal, mars 31, 1952.Le Procureur de la Compagnie, 32467-o LAZ.L.LINKOFF.NOTRE-DAME SECURITIES LTD.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Notre Dame Securities Ltd\", constituée en corporation en vertu de la Loi dçs compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général dc la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charge en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 23e jour d'avril 1952.Le Secrétaire, 32468 H.DENIGER.to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this 17th day of April 1952.C.FRED BERRY, 32433-o Secretary.Balmoral Liquors Limited Notice is hereby given that \"Balmoral Liquors Limited\", incorporated by letters patent of the province of Quebec, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, April 16, 1952.MEUNIER & HÉBERT, Attorneys for Balmoral Liquors Limited.32439-o - Laurentian Resorts Limited Notice is hereby given that \"Laurentian Resorts Limited\", incorporated by letters patent of the province of Quebec, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, April 16, 1952.MEUNIER & HÉBERT, Attorneys for 32440-o Laurentian Resorts Limited.LEGAL NOTICE Under the Quebec Companies' Act (R.S.Q.1941,\" chapter 276 and amendments), \"Lann Specialties Ltd.\", hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender the charter of the company.Dated at Montreal, this 17th of April, 1952.A.J.ISAIF, 32441-0 Secretary.LEGAL NOTICE In accordance with the provisions of the Quebec Companies Act, \"City Parcel Delivery Inc.\" hereby gives notice that it will apply to the Attorney General for leave to surrender its Charter from and after such date as he may determine.Montreal, March 31, 1952.LAZ.L.LINKOFF.324670 Solicitor for the Company.NOTRE DAME SECURITIES LTD Notice is hereby given that the \"Notre Dame Securities Ltd.\", a corporation constituted under the Quebec Companies Act and having its Head Office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Compagnies Act.Dated at Montieal, this 23rd day of April, 1952.H.DENIGER.32468-0 Secretary.Compagnies dissoutes Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, Companies Dissolved Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability 1120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 8A, N° 17 article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Artrust Holding Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 15 septembre.1931.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 avril 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Corn's Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 27 novembre 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 avril 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Crackle Gold Mines Limited\"(No Personal Liability)\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 septembre 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 avril 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 avril 1952., L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"La Compagnie Industrielle de Mis-tassibi, Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 septembre 1927.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 avril 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \" La Corporation d'Aqueduc C.F.L.P.R.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 18 mai 1935.enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Artrust Holding Corporation\" incorporated by letters patent dated September 15, 1931.Notice is also hereby given that from and after April 15, 1952, the said company shall be dissolved.Dated at the oflice of the Attornev General, April 16, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Corn's Limited\" incorporated by letters patent dated November 27, 1950.Notice is also hereby given that from and after April 15, 1952.the said company shall be dissolved.Dated at the office of the Attornev General, April 16, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Crackle Gold Mines Limited\" (No Personal liability) incorporated by letters patent dated September 12, 1945.Notice is also hereby given that from and after April 15, 1952 the said company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this April 16, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Compagnie Industrielle de Mistassibi, Limitée\" incorporated by letters patent dated September 26, 1927.Notice is also hereby given that from and after April 15, 1952.the said company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, April 16, 14)52.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Corporation d'Aqueduc C.F.L.P.R.\" incorporated by letters patent dated May 18, 1935. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1121 Avis est de plus donné qu'à compter du 1er mai 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte dc la compagnie \"La Ferme Laviolette Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 29 décembre 1938.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 avril 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 avril 1952.4 L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Lutom Manufacturing Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 23 avril 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 avril 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 16 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-0 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Rialto Investment & Realties Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 novembre 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du 1er mai 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32423-o L.DÉSILETS.Département de l'Instruction publique No.398-52.Québec, le 9 avril, 1952.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de la ville de Saint-Jean, dans le comté de Saint-Jean, en celui de \"Cité de Saint-Jean\".Le Surintendant de l'Instruction publique.32397-16-2-0 0.J.DESAULNIERS.Notice is also hereby given that from and after May 1st, 1952, the said company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, May 2, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Ferme Laviolette Limitée\" incorporated by letters patent dated December 29, 1938.Notice is also hereby given that from and after April 15, 1952.the said company shall be dissolved.Dated at the office of the Attornev General, April 16, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lutom Manufacturing Corporation\"incorporated by letters patent dated April 23, 1945.Notice is also hereby given that from and after April 15, 1952.the said company shall be dissolved.Dated at the oflice of the Attorney General, April 16.1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Notice is hereby given- that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Rialto Investment & Realties Limited\" incorporated by letters patent dated November 30.1945.Notice is also hereby given that from and after May 1st, 1952, the said company shall be dissolved.Dated ati.be office of the Attorney General, May 2, 1952.L.DÉSILETS, 32423 Deputy Attorney General.Department of Education No.398-52 Quebec, April 9, 1952.Application is made to change the name of the school municipality of the town of St-John's, in the County of St-John's, into that of \"City of St-John's\".O.J.DESAULNIERS.32397-16-2 Superintendent of Education. 1122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 N° 5-10-50.Québec, le 21 avril 1952.No.540-50.Quebec, April 21, 1952.Demande est faite dc détacher de la municipalité scolaire de Saint-Théophile, dans le comté de Beauce et de former en municipalité scolaire distincte sous le nom dc Metgermctte, même comté, le territoire suivant savoir: 1.Tout le canton de Mctgermette-Sud; 2.Tout le rang du chemin dc Kennebec, canton de Mar low; 3.Toute cette partie du canton dc Linièrc, borné au sud-est par la limite entre la Province dc Québec et l'État du Maine, U.S.A., au nord-est par le canton de Metgermette-Sud.au sud-ouest par les cantons de Jersey et de Marlow et enfin au nord-ouest par la ligne tel (pic tracée comme suit: en partant de la rivière du Loup, au sud-ouest du canton de Linièrc, cette ligne suit d'abord la ligne separative entre les lots 77 et 78 du rang 1.du canton de Linièrc, à compter d'Aubin de l'Isle jusqu'à la continuation ou aux abouts, de là elle suit ensuite la ligne separative entre les abouts 77 et 78 de la continuation du rang 1 du canton de Linièrc, à compter d'Aubin de l'Isle jusqu'au rang 2 section B, canton de Linièrc, dc là elle suit la ligne separative entre le rang 2 section B Liniè're et les abouts de la continuation du rang 1, Linièrc à compter d'Aubin de l'Isle jusqu'à la ligne.separative entre les lots 05 et 06 du rang 2 section B, canton de Linièrc, dc là elle suit cette dernière ligne separative jusqu'au rang 3 section B Linièrc ensuite elle suit le coté nord-ouest des lots 35 rang 3 section B, canton dc Linièrc et 35 rang 4, section B.canton de Linièrc jusqu'au canton de Mctgermette-Sud.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32447-17-2-0 O.J.DESAULNIERS.Application is made to detach from the school municipality of Saint-Théophile, in the county of Bcauce and to form into a separate school municipality, under the name of Metgermette, same county, the following territory, to wit: 1.All the township of Metgermette-South; 2.All the Range of Kennebec Road, township of Marlow', 3.All that part of the Township of Linièrc, bounded on the southeast by the limit between the PKPvince of Quebec and the State of Maine, U.S.A., on the northeast, by the Township of Metgermette-South, on the southwest by the townships of Jersey and Marlow and finally, on the northwest, by the line traced as follows, starting from the Rivière du Loup, on the southwest of the township of Linière, this line first follows the division line between lots 77 and 78 of Range 1, of the township of Linière, beginning from d'Aubin de l'Isle, up to the continuation or abutments, thence, the line follows the division line between abutments 77 and 78 of the continuation of Range 1 of the township of Linière, starting from d'Aubin de l'Isle up to Ran£ of 1%): Professional employers.$ 9,000.00 Employees.9,000.00 $18,000.00 Exvenses: Salaries: Inspectors.$ 6,400.00 Secretary's office.5,200.00 Furniture.200.00 Representation fees.520.00 Stationery.450.00 Rent.600.00 Postage and telephone.150.00 Fidelity-bond.5.00 .Expenses re: Inspection.1,000.00 Expenses re: Audition.100.00 Legal fees.1,000.00 Meeting and travelling expenses.1,250.00 Board of Examiners .500.00 Miscellaneous.225.00 Surplus .400.00 $18,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, April 26,1952.32424-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Building Trades Parity Committee of St-Hyacinthe, Bagot and Rouville Counties, formed under decree number 2678, of July 12, 1940, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 412 of April 17, 1952, (section \"A\"), pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chaptc 163 and amendments,) to collect levies from the professional employers, the artisans and the employees subject to the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Levy The period of lew shall extend from the 1st of May 1952, to the 30th of April 1953 and apply as hereinafter mentioned: a) The professional employers governed by the decree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to ^ of 1% of the regular wages, bonuses and percentages paid to their employees of the trades governed by the decree.b) All the artisans subject to the decree must also pay to the Parity Committee % ol 1% of the lowest wages fixed for journeymen of their own trade.c) The employees governed by the said decree shall pay to the Parity Committee a sum equi. 1126 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N\" 17 à Y de 1% de leur salair-c fixe, pourcentage et boni.2.Mode dc percept 'ion En vue dc faciliter la perception de ces cotisations le Comité paritaire met des formules de rapport à la disposition ties employeurs professionnels.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque sen aine, à même le salaire de chacun dc ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et les l'aire parvenir audit comité en même temps que sa propre cotisation.Le rapport de l'employeur professionnel, accompagné ties cotisations doit être signé et adressé au Comité paritaire le ou avant le 5 de chaque mois.Le Comité paritaire a le droit et le pouvoir d'exiger Tasse mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier D'accord avec 'es dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre çt 31 décembre.Ci-annexé, un étal des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des métiers de la construction pour les comtés dc Saint-Hyacinthe, Bagot et Rouville, pour la période comprise entre le 1er mai 1952 et le 30 avril 1953.Budget du comité paritaire des métiers de la construction' pour les comtés de saint-hyacinthe, Bagot et Rouville du 1er mai 1952 au 30 avril 1953.Recettes: Cotisations fjj de 1%): Employeurs professionnels.84,650.00 Salariés.4,050.00 Artisans.650.00 Certificats de qualification.350.00 Divers.250.00 810,550.00 Déboursés: Salaires et frais d'inspections.87,550.00 Loyer.425.00 Tones, électricité, téléphone, poste.175.00 Impression, papeterie, accessoires de bureau.100.00 Bureau des examinateurs.320.00 Frais judiciaires et professionnels .40.00 Vérification des livres.30.00* Jetons dc présence et frais dc déplacement.'.1,210.00 Divers et imprévus.700.00 810,550.00 valent of Y of 1% of their regular wages, percentages and bonus.2.Mode of collection In, order to facilitate lie collection of these levies, the Parity Committee shall supply the professional employers with report forms.The professinoal employer shall have these report forms filled in and sent to the parity Committee every mouth.The professional employer shall collect at the end of each week, from the wages of every one of his employees, the sums owed to the Parity a committee and forward same tohc said Committee together with his own levies.The report of every professionnel employer, together with the levies, must be signed and sent to the Parity Committee on or before the 5th day of each month.The Parity Committee has the right to exact sworn reports when it deems it advisable.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financiel operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.An estimate of the receipts and disbursements of the Building Trades Parity Committee of St.Hyacinthe, Bagot and Rouville counties for the period comprised between May 1st, 1952, and April 30th, 1953 in annexed thereto.Budget of the Building trades Parity Committee ok St.Hyacinthe Bagot and Rouville counties from May 1st, 1952, to April 30th, 1953 Probable receipts: Assessments i}/2 of 1%): Professional employers.S4,650.00 Employees.4,650.00 Artisans.650.00 Certificates of competency.350.00 Miscellaneous.250.00 $10,550.00 Probable expenses: Salaries and inspection expenses .$7,550.00 Rent.425.00 Taxes, telephone, electricity, and postage.175.00 Printed matters, stationary, office equipment.100.00 Board of examiners.320.00 Judicial and professional fees.40.00 Auditing.30.00 Attendance fees and travelling expenses.1,210.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.700.00 $10,550.00 Le Sous-ministre* du Travail, GÉRARD TREMBLAY, ,c \u2022 , , ™ GERARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 26 avril 1952.32424-0 Quebec, April 26, 1952.32424-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 25 th, 1952, Vol.84, No.17 1127 AVIS DE PRÉLÈVEMENT NOTICE OF LEVY L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité conjoint du commerce des taverniers de Québec, établi en exécution du décret numéro 095, du 7 mai 1938, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 412 du 17 avril 1952, section \"B\" le tout, d'accord avec les dispostions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisatio)i La période de cotisation s'étend du 1er mai 1952 au 1er mai 1953; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 695 du 7 mai 1938 et amendements, doivent verser au Comité paritaire, une somme équivalente à 3^ de 1 % dc la liste des salariés, bonis et allocations qu'ils versent à leurs salariés régis par ledit décret.b) Les salariés régis par ledit décret doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leurs salaires, bonis et allocations.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la dispostion des employeurs professionnels, des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les nom, prénoms et adresses dc chaque salarié à leur emploi, sa qualification, le nombre d'heures dc travail régulières et supplémentaires effectuées par lui chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient dûment remplis, signés et transmis au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent au Comité paritaire et les transmettre audit comité mensuellement, en même temps que sa propre cotisation.Le rapport mensuel dc l'employeur professionnel, accompagné des cotisations du mois courant, doit être transmis au Comité paritaire pas plus tard que le 10 du mois suivant; consé-quemment, le rapport du mois de mai doit être transmis pour le 10 juin et ainsi de suite, de mois en mois.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité conjoint du Commerce des Taverniers de Québec, pour la période comprise entre le 1er mai 1952 et le 1er mai 1953.Comité Conjoint du Commerce des Taverniers de Québec The honourable Antonio Barrette, Minister of labour, hereby gives notice that the Parity Committee of the Tavern Keepers of Quebec, formed under decree number 695 of May 7, 1938 and amendments, has been authorized by a bylaw approved by Order in Council number 412, of April 17, 1952, part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from May 1st, 1952 to May 1st 1953; it is laid in ths following manner: a) The professional employers governed by the decree No.695 of May 7, 193S, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to )£, avenue Cartier, Québec, gérant du crédit, La Compagnie Paquet Limitée, Robert Béland, 19, 16ième_ rue est, Gros Pin, Québec, Commis en chef, La Compagnie Paquet Limitée, : juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Québec; Jean-Marie Lapointe, 9, de la Normandie, Québec, adjoint au secrétaire-exécutif de la Appointments His Honour the lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, to make the following appointments Quebec, February 27.1952.Messrs.The Reverend Horace G.Baugh, Rector of Trinity Church, of Morin Heights, Linton Armstrong, of Lachute to be Justices of the Peace, with jurisdiction over the judicial district of Terrebonne; Paul Lahaye, of Batiscan, .Nestor St-Cyr, merchant, of Villers, Co.of Nicolet to be Justices of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Trois-Rivières; J.Emile Laberge, Investigator, on the Quebec Social Allowances Commission, of Châ-teauguay Village to be Justice of the Peace over the judicial district of Beauharnois; Jules-Émile Thibault, Collector, 3223 Verdun Avenue, Verdun, Louis Gousset, Head shipper of the Dominion Oil Cloth & Linoleum Co.Ltd., 716 Jarry Street, J.Jacques Poulin, Teacher, 857, Des-noyers Street, Roland Lacombe, 2060 Delorimier Street, Leo O'Connell, B.A.Professor, 4647, Earnscliff, Frank Holship, Garage-keeper, 3815, St.James.Street, West, Rolland Lamoureux, Investigator and Collector, 3974 Masson Street, all six of the City of Montreal, F.A.Storen, Investigator, on the Quebec Social Allowances Commission, 15 Desaulniers Blvd., St-Lambert, Paul Deschônes, 667, Moffat Avenue, Verdun, Councillor of the Finance Department of the Town of Verdun to be Justices of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Montreal 'Arthur Larouche, of Rivière du Moulin; to be Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Chicoutimi Roland Côté, Manager of the Caisse Populaire of Notre-Dame de Grâce, Quebec, 166, de Mazenod, Quebec; Charles-Auguste Sansfaçon, 51, Turgeon Street, Quebec, Inspector of the Parity Committee of the Quebec Truckers, Louis.Morin, 433^ Cartier Avenue, Quebec, Credit Manager, \"La Compagnie Paquet Limitée,\" Robert Béland, 19, 16th Street East, Gros Pin, Quebec, Chief Clerk, \"La Compagnie Paquet Limitée,\" to be Justices of the Peace with jurisdiction over the judicial 1146 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1962, Tome 84, N* 17 Corporation, des entrepreneurs en plomberie et chauffage de la province Québec: juge de paix avec juridiction sur toute la province de Québec; M.l'abbé Louis-Philippe Duclos, Collège de Lévis, Aumônier dc la Caisse Populaire et vicaire desservant de la mission dc Kinnear's Mills, comté de Mégantic: juge de paix avec juridiction sur les districts judiciaire de Québec et d'Artha-baska; Paul Dumulon.de Rouyn, maître de poste, Roch Fortin, de Rouyn, gérant de la Compagnie d'assurance l'Industrielle: juges de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Rouyn-Noranda; Jacques Lavallée, 154, rue Lajoie Nord, Joliette, sténographe officiel: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire dc Joliette; Roland Henri Lefebvrc, de Chibougamau, registrairc de \"Claims\", à Chibougamau: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Roberval; David Richer, 33, rue Bour-que, Hull, commerçant: juge dc paix avec juridiction sur le district judiciaire de Hull; Amable Lcgros, directeur du bien-être social, de la cité de Granby: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Bedford; Roland St-Pierre, secrétaire, dc Scnnetcrrc: juge de paix avec juridiction sur le district judiciare d'Abitibi; Albert Alarie, de Stc-Anne-de-la-Pocatièrc: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Kamouraska; \u2014 Les juges de paix nommés dans le présent paragraphe le sont aux fins de recevoir le serment seulement, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des Tribunaux judiciaires, Status Refondus, 1941, chapitre 15.20 mars 1952.MM.J.-Adrien Boileau, 327, 1ère Rue, à l'emploi de The Independent Order of Forestecs, Leopold Poulin, ingénieur à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus, tous deux de Québec: juges de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Québec; J.-E.Bcaulieu, 924, est, rue Bélanger, \u2022 Montréal, député-protonotaire de la Cour supérieure, Montréal, Robert Remington,'B.A., 179, Bould des Prarirics, Laval-des-Rapides, secrétaire-greffier de la Régie des Loyers sur l'Ile Jésus, A.-E.Beaupré, Lachine, lieutenant de section, Corps d'aviation Royal Canadien à Lachine, A.S.Carpenticr, agent d'assurance, 2399, rue Monsabré, Montréal, tous six: juges de.paix avec juridiction sur le district judiciaire de Montréal; Yves Boivin, de Naudville: juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Roberval; Christophe Chouinard, marchand et Ambroise Picard, entrepreneur, tous deux de Pentecôte; juge de paix avec juridiction sur le district judiciaire de Saguenay; \u2014 Les juges de paix nommés dans le présent paragraphe le sont aux fins de recevoir le serment seulement, conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi des Tribunaux judiciaires, Statuts refondus 1941, chapitre 15.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, de nommer par lettres patentes sous le grand sceau de la province, au nom de Sa Majesté, la personne dont le nom suit, savoir: 9 avril 1952.M.Antonio Pelletier, de Québec, membre du Barreau de la province : conseil en Loi de la Reine.32423-0 district of Québec; Jean-Marie Lapointe, 9 de la Normandie, Quebec, Assistant to the Executive-Secretary of the Plumbing and Heating Contractors Corporation of the Province of Quebec; to he Justice of the Peace with j risdiction over the whole Province of Quebec: Re.Father Louis-Philippe Duclos, Levis College, Chaplain of \"La Caisse Populaire\" and c irate for the Kinnear's Mills Mission, county of Mcgantic to be Justice of the Peace with jurisdiction ovei the judicial districts of Quebec and Arthabaska Paul Dumulon, of Rouyn, Post-Master, Roch Fortin, of Rouyn, Manager of the \"Compagnie d'Assurance l'Industrielle to be Justices of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Rouyn-Noranda; Jacques Lavallée, 154 Lajoie Street, North, Joliette, Official Stenographer to be Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Joliette; Roland Henri Lefebvrc, of Chibougamau, Registrar of Claims, at Chibougamau to be Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Roberval; David Richer, 33 Bourque Street, Hull, dealer to be Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial distiict of Hull; Amable Lcgros, Director of Social Welfare, of the City of Granby to be Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Bedford Roland St-Pierre, Secretary, of Senne-terre to be Justice of the Peace, with jurisdiction over the judicial district of Abitibi: Albert Alaiie, of Ste-Anne-de-la-Pocatière: to be Justice of the Peace with juiisdiction over the judicial district of Kamouraska: The Justices of the Peace named in the present paragraph are appointed as such for the purposes of administering the oath only, pursuant to the provisions of section 358 of the Courts of Justices Act, Revised Statutes, 1941, chapter 15.March 20, 1952.Messrs.J.Adrien Boileau, 327 1st Street, in the employ fo The Independent Order of Foresters, Leopold Poulin, Engineer at \"Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus, both of Quebec: to be Justices of the Peace, with jurisdiction over the judicial district of Quebec; J.-E.Bcaulieu, 924, Bélanger Street, East, Montreal, Deputy-Pro-thonotary of the Superior Court, Montreal, Robert Remington B.A., 179 Bould.des Prairies, Laval-des-Rapides, Secretary-Clerk of the Rental Commission on \"Ile Jésus\", A.E.Beaupré, Lachine, Section-Lieutenant, Royal Canadian Aviation Corps at Lachine, A.S.Carpentier, Insurance Agent, 2399 Monsabré Street, Montreal, all six: to be Justices of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Montréal; Yves Boivin, of Naudville: to be Justice of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Roberval: Christophe Chouinard, merchant and Ambroise Picard, contractor, both of Pentecôte; to be Justices of the Peace with jurisdiction over the judicial district of Saguenay; the Justices of the Peace named in the present paragraph are appointed as such for the purpose of administering the oath only, pursuant to the provisions of section 358, of the Courts of Justice Act, Revised Statutes, 1941, chapter 15.His Honour, the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, to appoint by letters patent under the Great Seal of the Province, in the name of Her Majesty, the person whose name follows, to wit: % .April 9, 1952.Mr.Antonio Pelletier, of Quebec, Member of the Bar of the Province: Queen's Counsel.32423 QbEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1962, Vol.84, No.17 1147 Sièges sociaux \"Bédard & Donaldson Limitée\" Avis est donné que la compagnie \"Bédard & Donaldson Limitée\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 mars 1952, en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, et ayant son bureau principal à Québec, P.Q.a établi son bureau au numéro 190 avenue Plante, dans la ville de Québec-Ouest.A compter de la date du présent avis, le dit bureau sera considéré comme le bureau principal dc la Compagnie.Daté à Québec, ce 2()ième jour de mars 1952.Le Secrétaire, 32434-o ALBERT PAQUET.\"Duchesne Auto Limitée\" Avis est par les présentes donné que la compagnie Duehesnc Auto Limitée, corporation constituée par lettres patentes dc la Province de Quebec en date du orrze mars mil neuf cent cinquante-deux, ayant le siège de ses affaires à Naudville, dans le district judiciaire de Roberval, a établi son bureau ou domicile légal: boulevard Dcquen, à Naudville, comté de Lac St-Jcan.Chicoutimi, le l&jnars 1952.Le Secrétaire, 32435-o JEAN-CHARLES DUCHESNE.Extrait des minutes d'une assemblée des directeurs de \"Le Palais des Sports Inc.\" tenue le 29 février 1952.\"Sur proposition dûment secondée il est résolu que le siège social de la compagnie soit fixé à 67, Côte d'Abraham, Québec.\" Québec, 29 février 1952.Certifié vraie copie.(Sceau) * Le Président, 32436-0 E.-FERNAND GUAY.Avis est donné que la Compagnie \"Quebec Glassheat Limited\" a établi son siège social à 3, rue Des Callièrcs, en les cités et district de Québec.Province de Québec.Signé, ce 1er jour d'avril 1952.Le Secrétaire, 32437-0 HENRI BEAUPRÉ.La Cie Martel, Limitée Règlement N° 1 (Changeant le siège social de la compagnie) Il est statué par le règlement n° 1 : Que le bureau principal de \"La Cie Martel, Limitée\" soit changé de localité du village de St-Nazaire.comté dc Chicoutimi, province de Québec, en la ville de St-Félicien, 9, rue Carillon, comté de Roberval, province de Québec.Le Secrétaire-trésorier, 3243S PAUL MARTEL.Canadian Sport Enterprises Inc.Limited Extrait des minutes d'une assemblée générale spéciale dés actionnaires de \"Canadian Sport Enterprises Inc.Limited\", tenue le 12 mars 1952, à laquelle assemblée assistaient tous les actionnaires de la compagnie, qui ont adopté le règlement suivant: Head Offices \"Bédard & Donaldson Limitée\" Notice is given that the company \"Bédard & Donaldson Limitée\" incorporated by letters patent bearing date March 14, 1952, under the Québec Companies' Act, and having its head office in Quebec, P.Q.has established its office at 190 Avenue Plante, in the town of Quebec Ouest.From and after the date of the present notice the said office will be considered as being the head office of the Company.Given at Quebec, this 20th day of March 1952.ALBERT PAQUET, 32434-0 Secretary.\"Duchesne Auto Limitée\" Notice is hereby given that the company \"Duchesne Auto Limitée\", incorporated by letters patent of the Province of Quebec, dated the eleventh day of March, one thousand nine hundred and fifty-two, having its head office at Naudville, in the judicial district of Roberval, has established its office or legal domicile at: Boulevard Dequen, at Naudville, county of Lake St.John.Chicoutimi, March 18, 1952.JEAN-CHARLES DUCHESNE 32435 Secretary.Extract from the Minutes of a meeting of Directors of \"Le Palais des Sports Inc.\", held on February 29, 1952.\"On motion duly seconded, it is resolved that the head office of the Company be fixed at 67, Côte d'Abraham, Quebec.\" Quebec, February 29, 1952.Certified True Copy.(Seal) E.FERNAND GUAY, 32436 President.Notice is hereby given that the Company \"Quebec Glassheat Limited\" has established its head office at 3 Des Callières Street, in the city and District of Quebec, Province of Quebec.Signed, this 1st dav of April, 1952.HENRI BEAUPRÉ, 32437 ' Secretary.La Cie Martel, Limitée By-law N° 1 (Changing the head Office of the Company) It is enacted by By-law N°.1.That the head office of \"La Cie Martel, Limitée\" be changed from the locality of the village of St-Nazaire, county of Chicoutimi, Province of Quebec, to the town of St-Félicien, 9 Carillon Street, county of Roberval, Province of Quebec.PAUL MARTEL, 32438 Secretary-Treasurer.Canadian Sport Enterprises Inc.Limited Extract of the Minutes of a special general meeting of the shareholders of \"Canadian Sport Enterprises Limited\", held on March 12, 1952, at which meeting assisted all the shareholders of the company, who adopted the following by-law: 1148 GAZETTE OFFICIELLE.DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N° 17 Règlement N° 4'8: Le siège social de la compagnie est changé d'endroit, du no 2110 est, rue Ontario au no 2490, nie Mont-Royal, en les cité et district de Montréal.Cer' ifîé copie conforme.^ Le Secrétaire, 32457-0 PAUL-MARCEL LORTIE.Canada, province de Québec, district de Bedford Avis de la situation du siège social de \"Grand.mont Construction Inc.\" Avis est donné que la Compagnie \"Grandmont Construction Inc.\", constituée en corporation par lettres patents en vertu dc la loi des compagnies de Québec, en date du 16 mai 1951, et ayant son bureau principal dans la cité de (i ran by, a établi son siège social au numéro 263 de la rue Principale, dans la cité de Granby, district dc Bedford.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie, comme étant son siège social.Granby, le 22ième jour d'avril 1952.Le Président, 32470-o GASTON POULIOT.Soumissions La Commission Scolaire fie Saint-David, comté de Lévis, demande des soumissions pour la construction d'une école à 6 classes avec garage pour l'autobus scolaire.Les plans et devis sont présentement au bureau du soussigné, secrétaire-trésorier.Il est entendu que la Commission Scolaire se réserve le droit de n'accepter ni la plus basse ni la plus haute soumission, ni même aucune, si elle le \"juge à propos.Les soumissions devront être accompagnées d'un chèque accepté équivalent à 10% de ladite soumission.Les soumissions seront reçues jusqu'à samedi soir le 10 mai à 7 heures p.m., heure avancée ou elles seront ouvertes.Le Secrétaire-trésorier, 32472-o Signé: LÉON PAUL GAGNON.Province de Québec St-Simon-de-Drummond .(Drummond) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Conrad Fouquette sec.-trés., St-Simon-de-Drummond, comté de Drummond, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 12 mai 1952, pour l'achat de $244,000 d'obligations de la corporation de St-Simon-de-Drummond, comté de Drummond datées du 1er juin 1952, et remboursables par séries du 1er juin 1953, au 1er juin 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 4J^% par année payable semi-\u2022annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: By-law No.48 The head office of the company is changed from No.2110 Ontario Street East, to No.2490, Mount Royal Street, in the city and district of Montreal.Certified true copy.PAUL-MARCEL LORTIE, 32457 Secretary.Canada, Province of Quebec District of Bedford Notice of the Situation of the Head Office of \"Grand.mont Construction Inc\" Notice is hereby given that the company \"Grandmont Construction Inc\", incorporated by letters patent under the Quebec Companies Act, on the 16th day of May, 1951, and having its head office in the city of Granby, has established its office at number 263 Principale Street, in the City of Granby, district of Bedford.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Granby, April 22, 1952.GASTON POULIOT, 32470 President.Tenders The School Commission of Saint-David, Co.Levis, is asking for tenders for the erection of a six-room school house, with a garage, for a school-bus.Plans and specifications are actually in the.office of the undersigned, the Secretary-Treasurer.It is understood that the School Commission does hot bind itself to accept the highest, nor the lowest, nor any of the tenders, should they deem advisable.Tenders must be accompanied by an accepted cheque equal to 10% of the said tender.Tenders will be received up to 7 o'clock p.m., (Daylight Saving Time, May 10, 1952, at which time they will be opened.LÉON PAUL GAGNON, 32472 Secretary-Treasurer.Province of Quebec St-Simon-de-Drummond (Drummond) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Conrad Fouquette Sec.-Trea., St-Simon of Drummond, county of Drummond, until 8 o'clock p.m., Monday, May 12, 1952, for the purchase of an issue of $244,000 of bonds of the Municipal Corporation of St-Simon of Drummond, county of Drummond dated June 1st, 1952 and redeemable serially from June 1st, 1953 to June 1st, 1972 inclusively, with interest at a rate not exceeding 4\\4% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.84, No.17 1149 Tableau d'amortissement \u2014 $2A4,000.\u2014 20 ans.Année Capital 1er juin 1953.$ 6,000.00 1er juin 1954.6,500.00 1er juin 1955.7,000.00 1er juin 1956.7,500.00 1er juin 1957.8,000.00 1er juin 1958.9,500.00 1er juin 1959.10,000.00 1er juin 1960.10,500.00 1er juin 1 61.11,500.00 1er juin 1962.12,000.00 1er juin 1963.12,500.00 1er juin 1964.13,000.00 1er juin 1965.13,500.00 1er juin 1966.14,500.00 1er juin 1967.15,000.00 1er juin 1968.15,500.00 1er juin 1969.16.500.00 1er juin 1970.17,000.00 1er juin 1971.18,500.00 1er juin 1972.19,5'JO.OO Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Québec, à Montréal ou à Drummondville.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être- accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance spéciale du conseil qui sera tenue lundi, le 12 mai 1952, à 8 heures p.m., à l'école Notre-Dame de St-Simon-de-Drummond.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Simon-de-Drummond (Comté de Drummond), ce 23 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, M.CONRAD FOUQUETTE, St-Simon-de-Drummond, (Drummond), P.Q.32471-0 Table of redemption \u2014 $244,000 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1953.$ 6,000.00 June 1st, 1954 .6,500.00 June 1st, 1955 .7,000.00 June 1st, 1956 .7,500.00 June 1st, 1957 .8,000.00 June 1st, 1958 .9,500.00 June 1st, 1959.10,000.00 June 1st, 1960 .10,500.00 June 1st, 1961 .11,500.00 June 1st, 1962 .12.000.00 June 1st, 1963 .12,500.00 June 1st, 1964 .13,000.00 June 1st, 1965 .13,500.00 June 1st, 1966 .14,500.00 June 1st, 1967 .15.000.00 June 1st, 1968 .15,500.00 June 1st, 1969 .16,500.00 June 1st, 1970 .17,000.00 June 1st, 1971 .18,500.00 June 1st, 1972 .19,500.00 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Quebec, Montreal or at Drummondville.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the of date their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a special meeting of the Council to be held on Monday, May 12, 1952, at S o'clock p.m., at Notre-Dame of St-Simon of Drummond school.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St-Simon-of-Drummond (County of Drummond), April 23, 1952.CONRAD FOUQUETTE, Secretary-Treasurer, St-Simon-of-Drummond, (Drummond) P.Q.32471 Province de Québec Commission scolaire de la ville de Victoria ville (Comté d'Arthabaska) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" sreont reçues par le soussigné, J.-Rod.Houle, sec.-trés., CP.22, Victoriaville, comté d'Arthabaska ou à l'hôtel de ville de Victoriaville jusqu'à 8 heures p.m., jeudi le 15 mai 1952, pour l'achat de $340,000.d'obligations de la commission scolaire de la ville de Victoriaville datées du 1er avril 1952 et remboursables par séries du 1er avril 1953 au 1er avril 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'exc.pas 4J^% par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau,/!'amortissement est le suivant: Province of Quebec School Commisioin of the Town of Victoriaville (County of Arthabaska) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.Rod.Houle, Sec.-Treas., P.O.Box 22, Victoriaville, county of Arthabaska or at the Town Hall of Victoriaville, Thursday, May 15, 1952, until 8 o'clock p.m., for the purchase of an issue of $340,000.of bonds of the School Commission of the town of Victoriaville dated April 1st, 1952 and redeemable serially from April 1st, 1953 to April 1st, 1972, inclusively, with interest at a rate not exceeding 4J^% per annum, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is_.as follows: 1150 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U avril 195», Torn* 84, N9 17 Tableau d'amortissement \u2014 $340,000.\u2014 SO ans Année Cavital 1er avril 1953 .x$17,000.00 1er avril 1954 .x 18,000.00 v 1er avril 1955 .x 19,000.00 1er avril 1956 .x 19,500.00 1er avril 1957 .x 20,500.00 1er avril 1958 .x 21,500.00 1er avril 1959 .x 23,000.00 1er avril 1960 .x 24,000.00 1er avril 1961 .x 25,000.00 1er avril 1962 .x 26,500.00 1er avril 1963 .10,000.00 1er avril 1964 .10,500.00 1er avril 1965 .11,000.00 1er avril 1966 .11,500.00 1er avril 1967 .12,000.00 1er avril 1968 .13,000.00 1er avril 1969 .13.500.00 1er avril 1970 .14,000.00 1er avril 1971 .15,000.00 1er avril 1972 .15,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $177,-222.50 accordé par le Secrétaire de la Province et payable en dix versements de $17,722.25 de 1953 à 1962 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de l'emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque à charte dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Victoriaville.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 15 mai 1952, à 8 heures p.m., à l'hôtel dc ville de Victoriaville.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Victoriaville (Comté de Arthabaska), ce 22 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, J,-ROD.HOULE.C P.22, Hôtel de ville, Victoriaville, Que.32462-0 Table of redemption \u2014 $340,000 \u2014 20 years Year Capital April 1st, 1953 .x$17,000.00 April 1st, 1954 .x 18,000.00 April 1st, 1955.x 19,000.00 April 1st, 1956 .x 19,500.00 April 1st, 1957 .x 20,500.00 April 1st, 1958 .x 21,500.00 April 1st, 1959 .;.x 23,000.00 April 1st, 1960 .x 24,000.00 April 1st, 1961 .x 25,000.00 April 1st, 1962 .x 26,500.00 April 1st, 1963 .'.10,000.00 April 1st, 1964 .10,500.00 April 1st, 1965 .11,000.00 April 1st, 1966 .'\"11,500.00 April 1st, 1967 .12,000.00 April 1st, 1968 .13,000.00 April 1st, 1969 .13,500.00 April 1st, 1970 .14,000.00 'April 1st, 1971 .15,000.00 April 1st, 1972 .15,500.00 The letters x indicate the years during annual payments of a total amount of $177,222.50 granted by the Provincial Secretary and payable inJten instalments of $17,722.25 from 1953 to 1962 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Capital and interest are payable'at the chartered bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Victoriaville.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941 subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on the Thursday, May 15, 1952, at 8 o'clock p-m.at the Town Hall of Victoriaville.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Victoriaville (Countv of Arthabaska), April 22nd, 1952.J.ROD.HOULE, Secrctarv-Treasurer.P.O.Box 22, Town Hall, Victoriaville, Que.32462 Province de Québec Province of Quebec Commission Scolaire de la Ville de Matane Commission Scolaire de la Ville de Matane (Comté de Matane) (County of Matane) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues.par le soussigné, J.-E.Dionne, sec.-trés., Hôtel de ville, Matane, comté de Matane, jusqu'à 8 heures p.m., mardi le 13 mai 1952 pour l'achat de $400,000 d'obligations de la commission scolaire de la ville de Matane, comté de Matane datées du 1er mars 1952 et remboursables par séries du 1er mars 1953 au 1er mars 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'exc.pas 4j/£% par année payable semi-annuellement les 1er.mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will-be received by the undersigned, J.E.Dionne, Sec-Treas., Town Hall, Matane, county of Matane, until 8 o'clock p.m., Tuesday, May 13, 1952, for the purchase of an issue of $400,000 of bonds of the School Commission of the town of Matane, county of Matane, dated March 1st, 1952, and redeemable serially from March 1st, 1953 to March 1st, 1972 inclusively, with interest at a rate not exceeding 4%% per annum, payable semiannually on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.81, No.17 1151 môme pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $400,000.\u2014 20 ans Année Capital 1er mars 1953.x$19,500.00 1er mars 1954.x 20,000.00 1er mars 1955.x 21,000.00 1er mars 1956.x 22,000.00 1er mars 1957.x 23,000.00 1er mars 1958.x 24,000.00 1er mars 1959.____ x 25,000.00 1er mars 1960.x 26,000.00 1er mars 1961.x 27,500.00 1er mars 1962.x 28,500.00 1er mars 1963.x 30,000.00 1er mars 1964.x 31,000.00 1er mars 1965.11,000.00 1er mars 1966.11,500.00 1er mars 1967.12,000.00 1er mars 1968.12,500.00 1er mars 1969.13,000.00 1er mars 1970.13,500.00 1er mars 1971.14,000.00 1er mars 1972.15,000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $260,000 accordé par le Secrétaire de la Province et payable en une annuité dc $21,674.00 et 11 annuités de $21,666.00 de 1953 à 1964 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de l'emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque à charte dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec, à Matane ou à Toronto.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 13 mai 1952 à 8 heures p.m., à l'hôtel de ville de Matane, comté de Matane.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.\u2014 Matane (Comté de Matane), ce 21ième jour d'avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, J.-E.DIONNE, Hôtel de ville, Matane, (Comté de Matane).32461-o Table of redemption\u2014$7,00,000\u201420 years Year Capital March 1st, 1953.xS19,500.00 March 1st, 1954.x 20,000.00 March 1st, 1955.x 21,000.00 March 1st, 1956.x 22,000.00 March 1st, 1957.x 23,000.00 * March 1st, 1958.x 24,000.00 March 1st, 1959.x 25,000.00 March 1st, 1960.x 26,000.00 March 1st, 1961.x 27,500.00 March 1st, 1962.x 28,500.00 March 1st, 1963.x 30,000.00 March 1st, 1964.x 31,000.00 March 1st, 1965.11,000.00 March 1st, 1966.11,500.00 March 1st, 1967.12,000.00 March 1st, 1968.12,500.00 March 1st, 1969.13,000.00 March 1st, 1970.13,500.00 March 1st, 1971.14,000.00 March 1st, 1972.15,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $260,000 granted by the Provincial Secretary and payable in an annuity of $21,674.00 and 11 annuities of $21,666.00 from 1953 to 1964 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Capital and interest are payable at the chartered bank mcntionned in the loan procedure at Montreal, Quebec, Matane or at Toronto.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, May 13,1952.at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of Matane, County of Matane.The commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Matane, (County of Matane), this April 21st, 1952.J.E.DIONXE, Secretary-Treasurer, Town Hall, Matane, (County of Matane).32461 Province de Québec Ville de Montmorency (Québec) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Gaston St-Pierre, secrétaire-trésorier, B.P.169, Ville de Montmorency, jusqu'à 8 heures P.M., lundi le 12 mai 1952, pour l'achat de $50,000.00 d'obligations de la ville de Montmorency, datées du 1er mai 1952 et remboursables par séries du Province of Quebec, Village de Montmorency (Québec) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Gaston St-Pierre, Secretary-Treasurer, P.O.Box 169, Town of Montmorency, until 8 o'clock p.m., Monday, May 12, 1952, for the purchase of an issue of $50,000 of bonds of the town of Montmorency, dated May 1st, 1952 and redeemable serially from May 1st, 1152 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N\" 17 1er mai 1953 au 1er mai 19G7, inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 4^2% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $50,000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1er mai 1953.§4,000.00 1er mai 1954 .2,000.00 1er mai 1955 .2,500.00 1er mai 1956 .3,000.00 1er mai 1957 .3,000.00 1er mai 1958 .3,000.00 1er mai 1959 .3,000.00 1er mai 1960 .3,000.00 1er mai 1961 .3,000.00 1er mai 1962 .3,500.00 1er mai 1963 .3,500.00 1er mai 1964 .3,500.00 1er mai 1965 .4,000.00 1er mai 1966 .4,500.00 1er mai 1967 .4,500.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque à charte dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, Québec ou à Montmorency.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 12 mai 1952, à 8 heures P.M., à l'hôtel de ville de Montmorency.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ville de Montmorency (Comté de Québec), ce 23 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, M.GASTON ST-PIERRE Ville de Montmorency, B.P.169.(Québec), P.Q.32469-0 1953 to May ls?, 1967 inclusively, with interest at a rate not exceeding 4^£% per annum, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows : Table of Redemption \u2014 $50,000 \u2014 15 years \u2022 Year Capital May 1st, 1953.$4,000.00 May 1st, 1954.2,000.00 May 1st, 1955;.2,500.00 May 1st, 1956.3,000.00 May 1st, 1957.3,000.00 May 1st, 1958.3,000.00 May 1st, 1959.3,000.00 May 1st, 1960.3,000.00 May 1st, 1961.3,000.00 May 1st, 1962.3,500.00 May 1st, 1963.3,500.00 May 1st, 1964.3,500.00 May 1st, 1965.4,000.00 May 1st, 1966.4,500.00 .May 1st, 1967.4,500.00 Capital and interest are payable at the chartered bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Montmorency.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday May 12, 1952, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of Montmorency.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Town of Montmorency, (County of Quebec), April 23, 1952.GASTON STxPIERRE, Secretary-Treasurer.P.O.Box 169, Town of Montmorency, (Quebec) P.Q.32469 Province de Québec Ville de Bourlamaqtje (Comté d'Abitibi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Albert Philbert, secrétaire-trésorier, 42 avenue Perrault, Bourlamaque, comté d'Abitibi, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi, le 14 mai 1952, pour l'achat de $113,000 d'obligations de la ville de Bourlamaque, comté d'Abitibi, datées du 1er mai 1952 et remboursables par séries du 1er mai 1953 au 1er mai 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 5% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission, ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Province of Quebec Town of Bourlamaque (County of Abitibi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Albert Philbert, Secretary-treasurer, 42, Perrault Avenue, Bourlamaque Abitibi County, until 8 o'clock p.m, Wednesday, May 14th, 1952, for the purchase of an issue of $113,000 of bonds of the Town of Bourlamaque, Abitibi Country, dated May 1st, 1952 and redeemable serially from May 1st, 1953 to May 1st, 1972 inclusively, with interest at a rate not exceeding 5% per annum, payable semi-annually on May 1st and and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: QZlEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8L, No.17 1153 Tableau d'amortissement \u2014 $118,000 \u2014 20 ans.Année Capital 1er mai 1953.§5,000.00 1er mai 1954.5,000.00 1er mai 1955.5.00 .00 1er mai 1956____.5,000.00 1er mai 1957.5,000.00 1er mai 1958.5,000.00 1er mai 1959.5,000.00 1er mai 1960.6,000.00 1er mai 1961.6,000.00 1er mai 1962.6,000.00 1er mai 1963.6,000.00 1er mai 1964.6,000.00 1er mai 1965.6,000.00 1er mai 1966.' 6,000.00 1er mai 1967.6,000.00 1er mai 1968.6,000.00 1er mai 1969.6,000.00 1er mai 1970.6,000.00 1er mai 1971.6,000.00 1er mai 1972.6,000.00 Ces obligations sont émises en vertu du règlement d'emprunt No.57.Le règlement No.57, au montant de $113,000, avec un terme de vingt ans, a pour objet de financer la contruction d'une station de pompage pour égouts, de conduites d'égouts et d'une fosse septique.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Bourlamaque.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par \u2022 anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il effectura les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 14 mai 1952, à 8 heures p.m., au bureau du soussigné, 42, avenue Perrault, Bourlamaque, comté d'Abitibi.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bourlamaque, (Comté de Abitibi), ce 19 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, ALBERT PHILBERT, 42, avenue Perrault, Bourlamaque, (Comté d'Abitibi), P.Q.32443-0 Table of redemption \u2014$113,000 \u2014 20 years Year Capital May 1st, 1953.$5,000.00 May 1st, 1954.5,000.00 May 1st, 1955.5,000.00 Mav 1st, 1956.5,000.00 May 1st, 1957.5,000.00 May 1st, 1958.5,000.00 May 1st, 1959.5,000.00 May 1st, 1960.6,000.00 May 1st, 1961.6,000.00 May 1st, 1962.6,000.00 May 1st, 1963.6,000.00 May 1st, 1964.6,000.00 May 1st, 1965.6,000.00 Mav 1st, 1966.6,000.00 May 1st, 1967.6,000.00 May 1st, 1968.6,000.00 May 1st, 1969.6,000.00 May 1st, 1970.6,000.00 May 1st, 1971.6,000.00 May 1st, 1972.\u2022.6,000.00 The said bonds will be issued under Loan By-Law No.57 for the amount of $113,000 with twenty-year term, the object being to finance the construction of a sewage disposal plant, pump house and sewer line.Capital and interest arc payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or Bourlamaque.The said bonds arc, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at meeting of the Council to be held on Wednesday May 14th, 1952, at 8 o'clock p.m., at the office of the undersigned, 42 Perrault Avenue, Bourlamaque, Abitibi County.The Council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Bourlamaque, (County of Abitibi), this April 19th, 1952.ALBERT PHILBERT, Secretary-Treasurer, 42, Perrault Avenue, Bourlamaque, (Abitibi County), P.Q.32443-o Province de Québec Ville de Cowansville (Comté de Missisquoi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-R.Ouellette.sec.-trés.CP.880, Cowans-ville ou à l'hôtel de ville 153, rue Principale, Co-wansville, jusqu'à 8 heures p.m., mardi le 13 mai 1952 pour l'achat de $150,000.d'obligations de la ville de Cowansville, comté de Missisquoi datées du 1er mars 1952 et remboursables par séries du 1er mais 1953 au 1er mars 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'exc.pas 43^% par année payable semi-annuellement les 1er Province of Quebec Town of Cowansville (County of Missisquoi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, J.R.Ouellette, Sec-Treas., P.O.Box 880, Cowansville, or at the Town Hall, 153, Principale Street, Cowansville, Tuesday, May 13, 1952, until 8 o'clock p.m., for the purchase of an issue of $150,000 of bonds of the town of Cowansville, county of Missisquoi, dated March 1st, 1952, and redeemable serially from March 1st, 1953 to March 1st, 1972 inclusively, with interest at a rate not exceeding 4}^% per annum, payable semi-annually on September 1154 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84,' N° 17 septembre et 1er mars de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances, bleau d'amortissement est le suivant: 1st and March 1st of each.The rate of interest may bé the same for the whole issue or it may vary Le ta- according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $150,000.\u2014 20 ans Année Cavital 1er mars 1953.«5,000.00 1er mars 1954 .5,000.00 1er mars 1955 .5,000.00 1er mars 1956 .6,000.00 1er mars 1957.6,000.00 1er mars 1958 .6,000.00 1er mars 1959 .7,000.00 1er mars 1960 .7,000.00 1er mars 1961 .7,000.00 1er mars 1962.8,000.00 1er mars 1963 .8,000.00 1er mars 1964 .8,000.00 1er mars 1965 .9,000.00 1er mars 1966.9,000.00 1er mars 1967 .'.9,000.00 1er mars 1968.9,000.00 1er mars 1969 .9,000.00 1er mars 1970 .9,000.00 1er mars 1971 .9,000.00 1er mars 1972.9,000.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque à charte dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Cowansville.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- {>rend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur es obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées.à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 13 mai 1952 à 8 heures p.m., à l'hôtel de ville, 153, rue Principale, Cowansville.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Cowansville (Comté de Missisquoi), ce 21 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, J.-R.OUELLETTE.CP.880, Hôtel de Ville, 153, rue Principale, Cowansville, (Missisquoi).P.Q.32460-o Table of redemption \u2014 $150,000 \u2014 20 years Year .Capital March 1st, 1953 .85,000.00 March 1st, 1954 .5,000.00 March 1st, 1955 .5,000.00 March 1st, 1956 .6,000.00 March 1st, 1957 .6,000.00 March 1st, 1958 .6,000.00 March 1st, 1959 .7,000.00 March, 1st 1960 .7,000.00 March 1st, 1961 .7,000.00 March 1st, 1962 .8,000.00 March 1st, 1963 .8,000.00 March 1st, 1964 .8,000.00 March 1st, 1965.9,000.00 March 1st, 1966.9,000.00 March 1st, 1967 .9,000.00 March 1st, 1968 .9.000.00 March 1st, 1969.9,000.00 March 1st, 1970.9,000.00 March 1st, 1971 .9,000.00 March 1st, 1972.9,000.00 Capital and interest are payable at the chartered bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Cowansville.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed Will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesdav, May 13,1952, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall, 153 Principale Street, Cowansville.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Cowansville, (County of Missisquoi), April 21, 1952.J.R.OUELLETTE, Secretary-Treasurer, P.O.BOX 880, Town Hall, 153, Principale Street, Cowansville, (Missisquoi), P.Q.32460 Province de Québec Commission scolaire de la paroisse Ste-Anne-des-Monts (Comté de Gaspé-Nord) de Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions Jour obligations\" seront reçues par le soussigné, os Simard, secrétaire-trésorier, Anse Ste-Anne-des-Monts, comté de Gaspé-Nord, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 12 mai 1952, pour l'achat de $100,000 d'obligations de la commission scolaire de la paroisse de Ste-Anne-des-Monts, datées du 1er avril 1952 et remboursables par séries du 1er avril 1953 au 1er avril 1967 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 43^% par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux Province of Quebec School Commission of the parish of Ste-Anne-des-Monts (County of Gaspé-North) - Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will bfc received by the undersigned Jos Simard, Secretary-Treasurer,, Anse Ste-Anne-des-Monts, County of Gaspé-North, until 8 o'clock p.m., Monday, May 12, 1952, for the purchase of an issue of $100,000 of bonds of the School Board of Ste-Anne-des-Monts, dated April 1st, 1952 and redeamable serially from April 1st, 1953 to April 1st 1967, inclusively, with interest at a rate not exceeding 4M% per annum, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8k, No.17 1155 d'intérêt peut être le même pour toute l'émission issue or it may vary according to maturities, ou il peut varier suivant les échéances.Le ta- The table of redemption is as follows: bleau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 S100,000 \u2014 15 ans.Armée Capital 1er avril 1953 .x$22,000.00 1er avril 1954 .x 23,000.00 1er avril 1955 .x 24.000.00 1er avril 195G.2,000.00 1er avril 1957 .2,000.00 1er avril 1958 .2,000.00 1er avril 1959.2,500.00 1er avril 1960 .2,500.00 1er avril 1961.2,500.00 1er avril 1962 .2,500.00 1er avril 1963 .2,500.00 1er avril 1964 .3,000.00 1er avril 1965 .3,000.00 1er avril 1966 .3,000.00 1er avril 1967 .3,500.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total dc S69,904.accordé par le Secrétaire de la province et payable en un versement de §23,302 et deux versements de $23,301 chacun, de 1953 à 1955 inelusievement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Ste-Anne-des-Monts.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et conisdérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 12 mai 1952, à 8 heures p.m., au lieu ordinaire des séances, à l'école No 5, à Ste-Anne-des-Monts, comté de (Jaspé-Nord.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Anne-des-Monts, (Comté de (Jaspé-Nord), ce 18 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, JOS.SIMARD, Anse Ste-Anne-des-Monts, (Comté de Gaspé-Nord), P.Q.32444-o Table of redemption \u2014 $100,000 \u2014 15 years Year Capital April 1st, 1953 .x$22,000.00 April 1st, 1954 .x 23,000.00 April 1st, 1955 .x 24,000.00 April 1st, 1956 .2,000.00 April 1st, 1957 .2,000.00 April 1st, 1958 .2,000.00 April 1st, 1959 .2,5000.0.April 1st, 1960 .2,500.00 April 1st, 1961 .2,500.00 April 1st, 1962 .* 2,500.00 April 1st, 1963 .2,500.00 April 1st, 1964 .3,000.00 April 1st, 1965 .3,000.00 April 1st, 1966 .3,000.00 April 1st, 1967 .3,500.00 The letter \"x\" indicates the years during which payments of a total grant of $69,904 from the Provincial Secretary and payable in one instalment of $23,302 and two instalments of $23,301 each from 1953 to 1955 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec, or at Ste-Anne-des-Monts.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a Meeting of the School Commissioners to be held on Monday, May 12, 1952, at 8.00 p.m.at the ordinary meeting place, at School No.5, at Ste-Anne-des-Monts, county of Gaspé-North.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Ste-Anne-des-Monts, (County of Gaspé-North), this 18th of April, 1952.JOS.SIMARD, Secreta ry-Treasu rer.Anse Ste-Anue-dcs-Monts, (County of Gaspé-North).P.Q.32444 Ventes par Hesitations AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'eu vertu d'un jugement de la Cour Supérieure du district dc Montréal, en date du 3 avril 1952, dans une cause portant le N° 307672 dans laquelle William Kenneth Roy Hughes, surintendant, des cité et district de Montréal, est demandeur \"et Thomas Lewis Hughes, jardinier, du comté d'Alliston, province d'Ontario, Dame Mary Christine Margaret Hughes, épouse de Elgin Duncan Roth well, gardien, de la cité de Lachine, district de Montréal, ledit Elgin Duncan Rothwell pour autoriser sa- Sales by Licitations NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that by virtue of judgment of the Superior Court for the District of Montreal dated April 3, 1952, in a case bearing no.307672 wherein William Kenneth Roy Hughes superintendent, of the city and district of Montreal, is plaintiff and Thomas Lewis Hughes, gardener, of the county of Al liston in the Province of Ontario.Dame Mary Christina Margaret Hughes, wife of Elgin Duncan Rothwell.custodian, of the city of Lachine in the district of Montreal, the said Elgin Duncan Rothwell, to 1156 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome 84, N3 IV dite épouse, Dame Edith Elizabeth Hughes, épouse de Crawford McConnell, vendeur, de la ville de Lambeth, province d'Ontario, ledit Crawford McConnell pour autoriser sadite épouse, Dame Lillian Maude Miller Hughes, épouse de Robert W.Smith, comptable, de la ville de Lambeth, province d'Ontario, ledit Robert W.Smith pour autoriser sadite épouse, Dame Sarah Lilah Jean Hughes, épouse de Vernon McLat-chie, de la ville de Noranda, province dc Québec, ledit Vernon McLatchie pour autoriser sadite épouse, Dame Rose Christiana Hughes, veuve de Clarence Johnston, ménagère, de la ville de Thornbury, province d'Ontario; et les héritiers de feu Thomas William Hughes, charretier, ci-devant de la ville de Meaford, province d'Ontario, sont défendeurs, ordonnant la licitation de la propriété immobilière décrite comme suit: Ce certain emplacement ayant front sur l'avenue Maplewood et formant le coin de l'avenue Decelles, en la cité de Montréal, et étant composé comme suit: 1.Les subdivisions numéros deux cent cinquante-deux et deux cent cinquante-trois du lot originaire numéro vingt-huit (28-252 et 253) du village incorporé de Côte des Neiges, chaque subdivision contenant vingt-cinq pieds de largeur par quatre-vingt-quatorze pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins.2.Cette partie de terrain connue et désignée comme étant une partie de la subdivision numéro deux cent vingt-sept dudit lot numéro vingt-huit (28-ptie 227) aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de Côte des Neiges, mesurant quatorze pieds de largeur par cinquante pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et située en arrière desdites deux subdivisions numéros deux cent cinquante-deux et deux cent cinquante-trois, bornés au sud-est par lesdites deux subdivisions numéros deux cent cinquante-deux et deux cent cinquante-trois (252 et 253), au nord-ouest par le lot numéro trente et aux sud-ouest et nord-est par des parties de ladite subdivision numéro deux cent vingt-sept dudit lot numéro vingt-huit (28pties 227).3.La partie sud-ouest de la subdivision numéro deux cent cinquante-quatre dudit lot numéro vingt-huit (28-s.o.ptie 254) dudit village incorporé de Côte des Neiges, mesurant trois pieds et deux dixièmes de largeur par quatre-vingt-quatorze pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins bornée en front par ladite avenue Ma-pleton, en arrière par une partie de ladite subdivision numéro deux cent vingt-sept, au sud-ouest par ladite subdivision numéro deux cent cinquante-trois dudit lot numéro vingt-huit (28-253) et au nord-est par ladite avenue Decelles.4.Cette partie d'une ruelle connue et désignée comme étant une partie de'ladite subdivision numéro deux cent vingt-sept dudit lot numéro vingt-huit (28-ptie 227) dudit village incorporé de Côte des Neiges, mesurant quatorze pieds de largeur par trois pieds et.deux dixièmes de profon-deux, mesure anglaise et plus ou moins, bornée au nord-est par l'avenue Decelles, au sud-est par ladite subdivision numéro deux cent cinquante-quatre dudit lot numéro vingt-huit (28-254), au nord-ouest par ledit lot numéro trente et au sud-ouest par une partie de ladite subdivision numéro deux cent vingt-sept.authorize his said wife, Dame Edith Elizabeth Hughes, wife of Crawford McConnell, salesman, of the town of Lambeth in the Province of Ontario, the said Crawford McConnell, to authorize his said wife, Dame Lillian Maude Miller Hughes, wife of Robert W.Smith, accountant, of the town of Lambeth, in the Province of Ontario, the said Robert W.Smith, to authorize his said wife, Dame Sarah Lilah Jean Hughes, wife of Vernon McLatchie, of the town of Noranda in the Province of Quebec, the said Vernon McLatchie, to authorize his said wife, Dame Rose Christina Hughes, widow of Clarence Johnston, housewife, of the town of Thornbury in the Province of Ontario; and the Heirs of the late Thomas William Hughes, teamster, late of the town of Meaford, in the Province of Ontario are defendants, ordering the licitation of the immoveable property described as follows: That certain emplacement fronting on Maple-wood A venue, and forming the corner of Decelles Avenue in the city of Montreal, and being composed of : 1.Subdivisions numbers two hundred and fifty-two and two hundred and fifty-three of original lot number twenty-eight (28-252 and 253) of the incorporated village of Côte des Neiges, containing each subdivision twenty-five feet in width by ninety-four feet in depth, English measure and more or less.2.That part of land known and designated as being part of subdivision number two hundred and twenty-seven of the said lot number twenty-eight (28-pt.227) of the Official Plan and Book of Reference of the incorporated village of Côte des Neiges, containing fourteen feet in width by fifty feet in depth, English measure and more or less, and situated in rear of the said two subdivisions number two hundred and fifty-two and two hundred and fifty-three, bounded on the Southeast by the said two subdivisions numbers two hundred and fifty-two and two hundred and fifty-three (252 and 253), on the North-west by lot number thirty and on the South-west and Northeast by parts of the said subdivision number two hundred and twenty-seven of the said lot number twenty-eight (28-pts.227).3.The South-west part of the subdivision number two hundred and fifty-four of the said lot number twenty-eight (28-s.w.pt.254) of the said incorporated village of Côte des Neiges, containing three feet and two tenths of a foot in width by ninety-four feet in depth, English measure and more or less, bounded in front by the said Maplewood Avenue, in rear by part of the said subdivision number two hundred and twenty-seven, on the south-west by the said subdivision number two hundred and fifty-three of the said lot number twenty-eight (28-253) and on the North-east by the said Decelles Avenue.4.That part of a lane known and designated as being part of the said subdivision number two hundred and twenty-seven of the said lot number twenty-eight (28-pt.227) of the said incorporated village of Côte-des Neiges, containing fourteen feet in width by three feet and two-tenths of a foot in depth, English measure and more or less, bounded on the North-east by Decelles Avenue, on the South-east by the said subdivision number two hundred and fifty-four of the said lot number twenty-eight (28-254) ,on the North-west by the said Ipt number thirty and on the South-west by part of the said subdivision number two hundred and twenty-seven. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 26th, 1952, Vol.8i, No.17 1157 Avec la bâtissejdessus érigée portant le numéro civique 3301 de ladite avenue Maplewood.La propriété ci-dessus décrite sera mise à l'enchère et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, MERCREDI, le VINGT-ET-UN MAI 1952, à DIX heures ET QUINZE du matin (Heure normande l'Est ou Heure avancée de l'Est, selon celle en vigueur en la cité de Montréal), siégeant à chambre 31 de l'ancien Palais de Justice, rue Notre-Dame est, Montréal, ou dans telle autre chambre où la licitation peut être référée, sujette aux charges, clauses et conditions indiquées au cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite Cour; Et%ue toute opposition à fin d'annuler, à fin dc charge ou à fin de distraire à ladite licitation devra être déposée au greffe du protonotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication; Et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; Et à défaut par les parties intéressées de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Un dépôt de $1,500.00 sera exigé de tout offrant et enchérisseur avant de présenter une offre.Montréal, 8 avril 1952.Les Procureurs du demandeur, Scott, Hugessex, Macklaier, 32395-16-2 Chisholm, Smith & Davis.Canada, Province de Québec, District*des Trois-Rivières AVIS DE LICITATION (1047 c.p.c.) Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Trois-Rivières, dans le district des Trois-Rivières, le S avril 1952, dans une cause dans laquelle Simon Verte-feuille, cultivateur de la paroisse de St-Joseph de Maskinongé, P.Q., Louis Toupin, cultivateur de la paroisse de Ste-Thèclc, P.Q.Maurice Gin-gras, cultivateur, de Cluny, Province d'Alberta Camille Gingras, cultivateur, de Cluny, Province d'Alberta, Dame Jeanne Gingras, épouse sé-paréç^de biens de Louis Hébert, cultivateur, tous deux de Donnelly, province d'Alberta.et le dit Louis Hébert pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Dame Réa Gingras.épouse séparée de bien de'Fred Ouellette, fermier, tous deux de Donnelly, province d'Alberta, et le dit Fred.Ouellette, fermier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Dame Antonio Gingras, épouse séparée de biens de Télesphore Brûlé, cultivateur, de Donnelly, province d'Alberta, et le dit Télesphore Brûlé pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Dame Laura Verte-feuille, veuve de Arthur S.de Carufel, de St-Paul, état du Minnesota, U.S.A., Dame Oliva Vertefeuille, épouse séparée de biens, de Auguste Plante, commerçant, de la ville de Louise-ville, P.Q.et le dit Auguste Plante, pour autoriser son épouse aux fins des présentes.Oscar Vertefeuille, employé civil, de la cité de Montréal, P.Q., Lucien Vertefeuille, cultivateur de Montmartre, province de la Saskatchewan, Dame Florence Vertefeuille, veuve de Flavien Rémillard, de la ville de Louiseville, P.Q., Dame Yvonne Vertefeuille, épouse séparée de biens de Emile Lazure, cultivateur, de Windsor Mills, province d'Ontario, et le dit Emile Lazure aux fins d'autoriser son épouse aux présentes, Denis With the building thereon erected bearing the civic number 3301 of the said Maplewood Avenue.The property above described will be put up to auction and adjudged to the last and highest bidder on WEDNESDAY, the TWENTY-FIRST of MAY, 1952, at TEN FIFTEEN o'cloek of the forenoon (Eastern Standard Time or Eastern Daylight Saving Time, whichever may then be in force, in the city of Montreal) sitting the Court in Room 31 of the Old Court House.Notre-Dame Street East, Montreal, or in such other room to which the licitation may be referred, subject to the charges, clauses and conditions contained in the List of Charges deposited in the office of the Prothonotary of the said Court; And that any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication; And that any opposition for payment must be filed within six days after the adjudication; And failing the interested parties to file such oppositions within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.A deposit of $1,500.00 shall be exacted from each and every bidder before making a bid.Montreal, April 8, 1952.Scott, Hugessex, Macklaier, Chisholm, Smith & Davis, 32395-16-2-0 Attorneys for plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Trois-Rivières NOTICE OF LICITATION (1047 c.c.p.) Notice is hereby given that by virtue of judgment of the Superior Court, sitting at Trois-Rivières, in the District of Trois-Rivières, April ^.1952, in a case in which Simon Vertefeuille, farmer of the parish of St-Joseph of Maskinongé.P.Q.Louis Toupin, farmer, of the parish of Ste-Thccle, P.Q., Maurice Gingras, farmer, of Cluny, Province of Alberta, Camille Gingras, farmer, of Cluny, Province of Alberta.Dame Jeanne Gingras.wife separate as to property of Louis Hébert, farmer, both of Donnelly, Province of Alberta, and the said Louis Hébert to authorize his wife for these presents, Dame Rea Gingras, wife separate as to property of Fred Ouellette, farmer, both of Donnelly, Province of Alberta, and the said Fred Ouellette to authorize his wife for these presents.Dame Antonia Gingras, wife separate as to property of Télesphore Brûlé, farmer, of Donnelly, Province of Alberta, and the said Télesphore Brûlé, to authorise his wife for these presents, Dame Laura Vertefeuille.widow of Arthur S.de Carufel, of St-Paul, state of Minnesota, U.S.A., Dame Oliva Vertefeuille.wife separate as to property, of Auguste Plante, tradesman, of the town of Louiseville, P.Q., and the said Auguste Plante, to authorize his wife for these presents, Oscar Vertefeuille, civil employee, of the City of Montreal.P.Q., Lucien Vertefeuille.fanner, of Montmartre, Province of Saskatchewan, Dame Florence Vertefeuille.widow oF Flavien Rémillard, of the town of Louiseville.P.Q., Dame Yvonne Vertefeuille, wife separate as to property of Emile Lazure, farmer of Windsor Mills, Province of Ontario, and the said Emile Lazure to authorize his wife for these presents, Denis Vertefeuille, mechanic, of St-Joseph of Sorel, P.Q., 1158 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 26 avril 1952, Tome SU, N\" 17 Vertefeuille, mécanicien,
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.