Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 24 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1952-05-24, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 84, N° 21 1359 Vol.84, No.21 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act reipecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubu shed by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 24 mai 1952 AVIS AUX INTÊRESSSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7* La Gazette officielle d$ Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, May 24th, 1952 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Officiai Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1360 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, HA mai 1952, Tome 8A, N° 21 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glifse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 2G6 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: , Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.31753 \u2014 1-52 Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EX CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 55(5 Québec, le 14 mai 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverncur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans les comtés de Joliette, Berthier, Montcalm et l'Assomption.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la conven- receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u2014 1-52 Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 556 Quebec, May 14, 1952.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Par \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the construction industry in the counties of Joliette, Berthier, Montcalm and L'Assomption.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Lth, 1952, Vol.8L, No.21 1361 tion collective de travail relative à l'industrie de la agreement relating to the construction industry construction dans les comtés de Joliettc, Ber- in the counties of Joliette, Berthier, Mont» thier, Montcalm et l'Assomption, rendue obli- calm and L'Assomption, rendered obligatory gatoire par le décret numéro 1407 du 3 avril 1940, by the decree number 1407 of April 3, 1940, as amendé par les arrêtés numéros 146 du 24 janvier amended by Orders 146 of January 24, 1941, 1941, 1248 et 1904 des 27 mai et 30 juillet 1942, 1248 and 1904 of May 27 and July 30, 1942, 147 et 154 du 22 janvier 1943, 2255 du 23 juin 147 and 154 of January 22,1943, 2255 of June 23, 1944, 1541 du 27 avril 1945, 2853 et 4320 des 1944, 1541 of April 27, 1945, 2853 and 4320 of 17 juillet et 24 octobre 1946, 1116-D du 9 juillet July 17 and October 24, 1946, 1116-D of July 9, 1947, 421-D du 30 mars 1948, 362-A et 623-E 1947, 421-D of March30, 1948, 362-A and623-E des 31 mars et 15 juin 1949, 471-A et 973-A des of March 31 and June 15, 1949, 471-A and 973-A 26 avril et 30 août 1950 et 350-A du 4 avril 1951, of April 26 and August 30, 1950 and 350-A of ont présenté au Ministre du Travail une requête April 4, 1951, have submitted to the Minister à l'effet de modifier ledit décret; of Labour a request to amend the said decree; Attendu que ladite requête a été publiée dans Whereas the said request has been published la Gazette officielle de Québec, édition du 5 avril in the Quebec Official Gazette, issue of April 5,1952; 1952; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée Whereas no objection has been made against contre l'approbation des modifications proposées; the approval of the proposed amendments; Il est ordonné, en conséquence, sur la propo- Be it enacted, therefore, upon the recommen-sition de l'honorable Ministre du Travail: dation of the Honourable the Minister of Labour, Que ledit décret, numéro 1407, soit modifié That the said decree, number 1407, be amen-comme suit: - ded as follows: 1° L'article III est remplacé par le suivant: 1.Section III is replaced by the following: \"HI.Taux de salaires: Les taux de salaires \"III.Rates of wages: The following minimum minima suivants doivent être payés pour chacun rates of wages shall be paid for each one of the des métiers ci-après mentionnés: trades hereafter mentioned.\u2022 Salaire horaire Hourly rates Métiers \u2014 Trades: Zones I II Ajusteur de gicleur \u2014 Sprinkler fitter.$ 1.40 $ 1.40 Briqueteur (compagnon) \u2014 Bricklayer (journeyman).1.40 1.40 Poseur de blocs et terra-cotta et tireur de joint \u2014 Block and terra-cotta layer and joint pointer.1.40 1.40 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.'.0.85 0.85 2ème année \u2014 2nd year.0.95 0.95 3ème année \u2014 3rd year., 1.05 1.05 Brasseur de mortier \u2014 Mortar mixer.1.10 1.05 Brasseur de célanite \u2014 Celanite mixer.1.10 1.05 Charpentier et menuisier (compagnon) \u2014 Carpenter and joiner (journeyman).1.40 1.30 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.75 0.70 2ème année \u2014 2nd year.0.80 0.75 3ème année \u2014 3rd year.0.90 0.85 4ème année \u2014 4th year.1.00 0.95 Calfat \u2014 Caulker.;.1.10 1.05 Couvreur d'amiante autre que les mécaniciens en isolement en tuyauterie \u2014 Asbestos layer other than pipe insulation mechanics.1.40 1.30 Couvreur \u2014 ardoise, tuile \u2014 Roofer \u2014 slate, tile.1.40 1.30 Couvreur\u2014composition, gravier, sable, asphalte \u2014 Roofer\u2014composition, gravel, sand, asphalt.1.40 1.30 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.1.10 1.00 Charretier \u2014 Carter.1.05 1.00 Chauffeur (construction) \u2014 Fireman (construction).1.20 1.15 Conducteur de monte-charge \u2014 Freight elevator operator.1.05 1.05 Conducteur de tracteur \u2014 Tractor operator.1.25 1.25 Conducteur de rouleau compresseur (vapeur ou essence) \u2014 Roller operator (steam or gasoline).1.20 1.20 Conducteur de \"Bulldozer\" \u2014 Bulldozer operator.1.20 1.20 Conducteur de nivelleuse \u2014 Grader operator.1.20 1.20 Électricien (compagnon) \u2014 Electrician (journeyman).1.45 1.40 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.75 0.70 2ème année \u2014 2nd year.0.80 0.75 3ème année \u2014 3rd year.0.90 0.80 4ème année \u2014 4th year.1.00 0.95 Ferblantier, couvreur (compagnon), ouvrier-tôlier, boutique ou chantier \u2014 Tinsmith, roofer (journeyman), sheet-metal worker, shop or job.1.40 1.35 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.70 0.65 2ème année \u2014 2nd year.0.80 0.70 3ème année \u2014 3rd year.0.90 0.85 Finisseur de ciment \u2014 Cement finisher.1.35 1.30 Finisseur de plancher en mastic \u2014 Mastic floor finisher.- 135 1.30 Foreur et poudrier \u2014 Drill operator and blaster.1.35 1.30 1362 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2/, mai 1952, Tome 81, N° 21 Salaire horaire Hourly rates Métiers \u2014 Trades: Zones I II Forgeron sur chantier \u2014 Blacksmith on job.1.35 1.30 Journalier (ouvrier non qualifié) \u2014 Labourer (common worker).1.00 0.95 Homme de chaudière (boilerman) \u2014 Boilerman.1.00 0.95 Gratteur, polisseur et sableur de plancher \u2014 Floor scraping, polishing and sanding employees.;.1.40 1.30 Gréeur (à la main ou à la machine) \u2014 Rigger (hand or machine).1.40 1.30 Limeur de scie \u2014 Saw filer.1.40 1.35 Lettreur pour fins commerciales \u2014 Commercial letterer.1.50 1.50 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.80 0.80 2ème année \u2014 2nd year.0.85 0.85 3ème année \u2014 3rd year.1.00 1.00 4ème année \u20141th year.1.10 1.10 Manœuvre, porteur de briques, blocs, mortier, terra-cotta, que ce soit à l'oiseau, à la brouette, ou à la chaudière \u2014 Labourer, brick, block, mortar and terra-cotta carrier with hod, wheelbarrow or pail.-.1.10 1.05 Machiniste (millwright) \u2014 Millwright.140 1.30 Mécanicien en isolation de tuyauterie \u2014 Pipe insulation mechanic.1.40 1.30 Mécanicien de machine fixe ou mobile \u2014 Stationary or portable cngineman.1.10 1.05 Machiniste \u2014 Machinist.1.10 1.05 Peintrc-doreur \u2014 Painter-gilder.1.40 1.30 Peintre, aspergeur, décorateur, vitrier, poseur de papier-tenture et vernisseur de plancher (compagnon) \u2014 Painter, sprayman, decorator, glazier, paper hanger, floor varnisher (journeyman).1.25 1 15 Apprenti \u2014 Apprentice: 1 ère année \u2014 1 st year.0.75 0.70 2ème année \u2014 2nd year.0.80 0.75 3ème année \u2014 3rd year.0.85 0.80 4ème année \u2014 4th year.0.95 0.90 Plâtrier (compagnon) \u2014 Plasterer (journeyman).1.40 1.40 Apprenti \u2014 Apprentice: 1 ère année \u2014 1st year.f.0.80 0.80 2ème année \u2014 2nd year .'.0.90 0.90 3ème année \u2014 3rd year.1.00 1.00 Préposé aux sonnettes (bois ou béton) \u2014 Pile driver operator (wood or concrete) 1.15 1.05 Plombier, poseur d'appareil de chauffage, mécanicien en tuyauterie, poseur de brûleur à l'huile (compagnon) \u2014 Plumber, steamfitter, pipe mechanic, oil burner mechanic (journeyman).1.40 1.35 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.70 0.65 2ème année \u2014 2nd year.0.80 0.70 3ème année \u2014 3rd year.0.90 0.80 4ème année \u2014 4th year.'.1.00 0.90 Compagnon junior.1.15 1.05 Préposé aux compresseurs \u2014 Compressor operator.1.20 1.15 Poseur de lattes en métal ou de composition \u2014 Lather, metal or composition .1.25 1.25 Poseur de lattes en bois \u2014 Lather, wood.1.15 1.10 Préposé aux malaxeurs à vapeur ou à gazoline \u2014 Steam or gasoline mixer operator 1.20 1.10 Préposé aux malaxeurs à l'électricité ou au petit malaxeur à gazoline \u2014 Electric or small gasoline mixer operator.1.10 1.00 Préposé aux bouilloires (travail de plancher seulement) \u2014 Kcttleman (flooring only).1.10 1.00 Préposé aux machines à .polir le terrazzo (machine à sec) \u2014 Terrazzo polishing machine operator (dry).1.20 1.10 Préposé aux machines à polir le terrazzo (machine à l'eau) \u2014 Terrazzo polishing machine operator (wet).1.20 1.10 Préposé aux grues \u2014 Crane operator.1.20 1.10 Préposé aux pelles mécaniques \u2014 Power shovel operator.1.45 1.35 Poseur d'acier d'armature \u2014 Reinforcing steel erector.1.25 1.25 Poseur de liège (isolation) \u2014 Cork setter (insulation).1.40 1.30 Poseur de planchers en mastic \u2014 Mastic floor layer.1.40 1.30 Poseur de tuile, asphalte et terrazzo \u2014 Tile, asphalt and terrazzo layer.1.40 1.30 Poseur de marbre \u2014 Marble layer.1.40 1.30 Soudeur en tuyauterie (acétylène ou électricité) \u2014 Pipe welder (acetylene or electricity).1.40 1.30 Surveillant employé également comme chauffeur et devant posséder un certificat de la 4ième classe (sans limite de la durée journalière de travail); maximum de 72 heures \u2014 Watchman employed also as fireman and required to hold a 4th class certificate (without daily limitation of duration of work), weekly maximum 72 hours.1.08 0.98 Gardien sur le chantier, nuit et jour, sans limite de la durée quotidienne de travail, maximum hebdomadaire, 72 heures \u2014 Watchman on the job, night and day (without daily limitation of duration of work) weekly maximum, 72 hours.0.65 0.65 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Ath, 1952, Vol.84, No.21 1363 Salaire horaire Hourly rates Métiers\u2014Trades: Zones I II Chauffeur de bouilloire devant posséder un certificat de 4ème classe \u2014 Boiler fireman required to hold a 4th class certificate.1.08 0.98 Poi teur d'eau \u2014 Water carrier.0.90 0.80 Ratisseur d'asphalte \u2014 Asphalt raker.1.00 0.90 Pilonneur, lisscur et épandcur d'asphalte \u2014 Mon committed to the ramming \u2022 smoothing and spreading of asphalt.1.00 0.90 Préposé à la canalisation, matcur et soudeur \u2014 Men commited to the piping caulking and welding.1.00 0.90 Les contremaîtres préposés à la surveillance Foremen in charge of a group of three or more d'une équipe d'hommes doivent être rémunérés men shall be paid SO.10 more per hour than the au taux de SO.10 l'heure de plus que Me salaire rate established for the trade concerned.\" établi pour le métier quand il y a trois homme ou plus.\" « 2° Le paragraphe c) de l'article IV est rem- 2.Subsection \"c\" of section IV is replaced placé par le suivant: by the following: \"c) Tout travail exécuté en dehors des heures \"c) All time worked beyond the regular hours, réglementaires mais avant minuit doit être but before midnight, shall be paid time and one rémunéré au taux de salaire et demi et, après half, and that worked after midnight shall be minuit, à taux double du salaire.\" - paid double time.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté).(Document \"A\" annexed to the order).A.MORISSET, A.MORISSET, 32624-0 Greffier du Conseil Exécutif.32624-0 Clerk of the Executive Council.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 556 Number 556 Québec le 14 mai 1952.Quebec, May 14,1952.Présent: Le Lieutenant-Gouvcrneur-en-Conseil Present: The Lieutenant Governor in Council Section \"B\" Part \"B\" concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating au commerce de quincaillerie, ferronnerie, to the hardware, paint and building materials peinture et matériaux de construction dans les trade in the cities of Quebec and Levis and the cités de Québec et Levis et la ville de Lauzon.town of Lauzon.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de quincali-lerie, ferronnerie, peinture et matériaux de construction dans les cités de Québec et Levis et la ville de Lauzon, rendue obligatoire par le décret numéro 1090 du 7 mars 1940, amendé par les arrêtés numéros 4200 et 4252 des 28 novembre et 1er décembre 1940, 1043 du 30 avril 1941, 1168, 1756 et 3144 des 13 mai, 24 juillet et 20 novembre 1942, 2631 du 10 septembre 1943, 1431 du 28 avril 1944, 3499 du 1er septembre 1945, 1655 et 4717 des 10 mai et 14 novembre 1946, 1310-B du 12 août 1947, 68-B, 1162-A et 1763-B des 22 janvier, 9 septembre et 23 décembre 1948, 1029-A et 1198-C des 14 septembre et 27 octobre 1949, 915-A du 9 août 1950, 735-C du 12 juillet 1951 et 1396-B du 13 décembre 1951, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 5 avril 1952; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1090, soit modifié comme suit: 1° L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe \"l\" de l'article II: Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the hardware, paint and building materials trade in the cities of Quebec and Levis and the town of Lauzon, rendered obligatory by the decree number 1090 of March 7, 1940, as amended bv Orders 4200 and 4252 of November 28 and December 1, 1940, 1043 of April 30, 1941, 1168, 1756 and 3144 of May 13, Julv 24 and November 20, 1942, 2631 of September 10.1943.1431 of April 28, 1944, 3499 of September 1, 1945, 1655 and 4717 of May 10 and November 14, 1946, 1310-B of August 12, 1947, 68-B, 1162-A and 1763-B of January 22, September 9 and December 23, 1948, 1029-A and 1198-C of September 14 and October 27, 1949, 915-A of August 9, 1950, 735-C of July 12, 1951 and 1386-B of December 13, 1951, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 5, 1952; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; Be it enacted, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1090, be amended as follows: 1.The following paragraph is added to subsection \"I\" of section II: 1364 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2L mai 1952, Tome, 8Â, N° 21 \"Le Comité paritaire ou son bureau d'examinateurs pourra décider si les années d'expérience acquises dans un autre commerce peuvent être comptées pour déterminer la classification d'emploi d'un salarié.\" 2° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe \"b\" de l'article III est remplacé par le suivant: \"3.Du 15 juin au 15 septembre de chaque année, la semaine régulière de travail se termine à midi, le samedi.\" 3° A l'article IV, les taux de salaires minima mentionnés pour les classifications d'emploi ci-après énumérées, sont remplacés par les suivants : par samaine \"a) 1.Gérant.$61.00 2.Chef-comptable.54.50 3.1er commis à la vente.54.50 4.1er commis réception et expédi- tion.51.00 5.1er commis aux commandes.51.00 b) Livreur.43.50 c) Aide-livreur\u2014mois21 ans.27.50 Aide-livreur\u201421 ans et plus.32.00 d) Messager.14.00 /) Personnel masculin de bureau: 1ère année.20.50 2ème année.24.50 3èmc année.27.00 4ème année.31.50 5ème année.37.00 6ème année.41.00 7ème année.44.50 8ème année.47.50 9ème année.51.00 g) Commis à la vente: 1ère année.19.00 2ème année.22.50 3èmc année.27.00 4ème année.30.50 5ème année.35.50 6ème année.40.00 7ème année.42.00 8ème année.46.50 9ème année.51.00 h) Commis à rêceptioti et expédition: 1ère année.*.20.50 2ème année.24.50 3ème année.27.00 4ème année.31.50 5èmc année.34.50 6ème année.37.50 7ème année.38.50 8ème année.41.00 9ème année.43.50 0 Commis aux common des: 1ère année.20.50 2ème année.24.50 3ème année.27.00 4ème année.31.50 5ème année.34.50 6ème année.37.50 7ème année.40.00 8ème année.43.50 9èrae année.46.50 l'heure k) Commis supplémentaire.S0.86 I) Commis Surnuméraire .0.57 m) Personnel féminin de bureau: par semaine 1ère année.$19.00 2ème année.23.50 3ème année.28.00 4ème année.31.50 mm) Autre personnel féminin: 1ère année.18.00 2ème année.21.50 \"The Parity Committee or its Board of Examiners may decide whether the years of experience in another trade may be considergd to determine the classification of an employee.\" 2.Paragraph 3 of subsection \"6\" of section III is replaced by the following: \"3.From June 15 to September 15 of each year, the standard work week shall end at 12.00 (noon), on Saturday.\" 3.The minimum wage rates for the following classifications of employment, as mentioned in section IV, are replaced by the following: per week \"a) 1.Manager.$61.00 2.Chief-accountant.54.50 3.Head sales-clerk.54-50 4.Head receiving and shipping clerk.51.00 5.Head order clerk P.51.00 b) Delivery-man.43.50 c) Delivery-man's helper: under 21 years of age.27.50 21 years of age and over.32.00 d) Messenger.14.00 /) Male office clerk: 1st year.20.50 2nd year.24.50* 3rd year.27.00 4th year.31.50 5th year.37.00 6th year.41.00 7th year.44.50 8th year.47.50 9th year.:.51.00 g) Sales clerk: 1st year.¦.19.00 2nd year.22.50 3rd year.27.00 4th year.30.50 5th year.35.50 6th year.40.00 7th year.42.00 8th year.46.50 9th year.51.00 h) Receiving and shipping clerk: 1st year.20.50 2nd year.24.50 3rd year.27.00 4th year.31.50 5th year.34.50 6th year.37.50 7th year.38.50 8th year.41.00 9th year.43.50 i) Orders clerk: 1st year.20.50 2nd year.24.50 3rd year.27.00 4th year.31.50 5th year.34.50 6th year.37.50 7th year.40.00 8th year.43.50 9th year.46.50 per hour k) Extra clerk.$0.86 /) Supernumerary clerk.0.57 m) Female office clerk: per week 1st year.19.00 2nd year.23.50 3rd year.28.00 4th year.31.50 mm) Other female employees: 1st year.18.00 2nd year.21.50 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Lth, 1952, Vol 8L, No.21 1365 3ème année.25.50 4ème année.28.00 n) 1.Ouvriers de métiers qualifiés.49.50 2.Ouvriers de métiers non qualifiés 42.00 6) Apprenti Vheure 1ère année.0.43 2èmc année.0.54 3èmc année.0.65 4èmc année.0.76 p) Employé d'ouvrage général: a)Employé senior: par semaine moins de 25 ans.40.00 25 ans et plus.43.50 b) Employé junior.18.00 q) Gardien de nuit.37.50\" 4° Le chiffre \"827.50\" apparaissant au paragraphe \"r\" de l'article IV, est remplacé par \"830.00\".5° L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3 de l'article VI-B: \"Le Comité paritaire ou son bureau d'examinateurs pourra décider si les années d'expérience acquises dans un autre commerce peuvent être comptées pour déterminer la classification d'emploi d'un salarié.\" , 6° Les taux de salaires pour chacune des classifications d'emploi mentionnées au paragraphe 7 de l'article VI-B sont remplacés par les suivants: Occupation: par semaine \"a) 1.Gérant.S61.50 2.Chef-comptable.54.00 3.Premier commis à la vente.54.00 4.Premier commis d'entrepôt 1ère année.43.00 2ème année.47.50 b) Livreur.43.00 c) Aide-livreur: moins de 21 ans.27.00 21 ans et plus.33.00 - d) Personnel masculin de bureau: 1ère année.19.50 2èmc année.24.00 3ème année.27.00 4ème année.31.50 5èmeannée.36.00 6ème année.41.00 7ème année.45.50 8ème année.49.50 e) Employé d'entrepôt: 1ère et 2ème années d'expérience.33.50 après 2 ans d'expérience.39.00 /) Employé temporaire (l'heure) S0.86 g) Personnel féminin de bureau: 1ère année.19.50 2ème année.23.50 3ème année.27.00?4ème année.31.00\" Les parties consentent à ce que ces amendements soient obligatoires à compter du 21 avril 1952.(Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 32624-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 556 Québec, le 14 mai 1952.Présent : Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"C\" 3rd year.25.50 4thyear.28.00 n) 1.Skilled tradesman.49.50 2.Unskilled tradesman.\u2022 42.00 o) Trade apprentices: per hour 1st year.0.43 2nd year.0.54 3rd year.0.65 - 4th year.0.76 p) General hand: a) Senior employee: per week Under 25 years of age.40.00 25 years of age and over.43.50 b) Junior employee.18.00 q) Night watchman.37.50\" 4.The amount of \"827.50\", mentioned in subsection \"r\" of section IV, is replaced by \"$30.00\".5.The following paragraph is added to subsection 3 of section VI-B \"The Parity Committee or its Board of Examiners may decide whether the years of experience in another trade may be considered to determine the classification of an employee.\" 6.The wages rates for every classification of employment mentioned in subsection 7 of section VI-B are replaced by the following: Occupation: Weekly wages a) 1.Manager.-.S61.50 2.Chief accountant.54.00 3.Head sales clerk.54.00 4.Head warehouse-clerk : 1st year.43.00 2nd year.47.50 b) Delivery man.43.00 c) Delivery man's helper *(under 21 years of age.27.00 21 or over.33.00 d) Male office employees: 1st y ear.19.50 2nd year.24.00 3rd year.27.00 4th year.'.31.50 5th year.:.36.00 6th y ear.41.00 7th year.45.50 8th year.49.50 e) Warehouse employee: 1st and 2nd years experience.33.50 After 2 years experience.39.00 /) Temporary employee (per hour) .0.86 g) Female office employees : 1st year.19.50 2nd year.23.50 3rd year.27.00 4th year.31.00\" The contracting parties approve of the coming into force of these amendments from April 21, 1952.(Document \"B\" annexed to the order) A.MORISSET, 32624-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 556 Quebec, May 14, 1952.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"C\" Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse to the barber and hairdressing trades in the 1366 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2L mai 1952, Tome 84, N* 21 dans la cité de Hull et la ville de Buckingham, et un rayon de dix (10) milles de leurs limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la cité de Hull et la ville de Buckingham, et un rayon de dix (10) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret numéro 2246 du 27 août 1941, amendé par les arrêtés numéros 2918 du 3 novembre 1941, 1576 et 1754 des 2 et 24 juillet 1942, 441 et 3019 des 19 février et 21 octobre 1943, 2549 du 6 juillet 1945, 2850, 4466 et 4791 des 17 juillet, 31 octobre et 21 novembre 1946, 493-E du 21 mars 1947, 245-A, 422-F et 912-E des 26 février, 30 mars et 16 juin 1948, 625-C du 31 mai 1950 et 541-E du 30 mai 1951, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 5 avril 1952; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 2246, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe 6 de l'article III-A est remplacé par le suivant: \"6) Vacance payées: Toute salariée doit recevoir chaque année un montant équivalent à 2% du salaire de base gagné, à titre de rémunération pour ses vacances.Si une salariée quitte le service de son employeur avant d'avoir complété douze mois de service, elle doit recevoir quand même, en tel cas, une rémunération équivalente à 2% du salaire de base gagné à date.\" 2° Le paragraphe \"e\" de l'article IV est remplacé par le suivant: \"e) Vacances payées: Tout salarié doit recevoir chaque année un montant équivalent à 2% du salaire de base gagné, à titre de rémunération pour ses vacances.Si un salarié quitte le service de son employeur avant d'avoir complété douze mois de service, il doit recevoir quand même, en tel cas, une rémunération équivalente à 2% du salaire de base gagné à date.\" 3° \"Le Syndicat des Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses du District de Hull\" est substitué comme partie contractante de première part aux lieu et place de \"L'Association des Maîtres-Barbiers du District de Hull\" et \"L'Association des Coiffeuses de la Cité de Hull'\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 32624-0 Greffier du Conseil Exécutif.city of Hull and the town of Buckingham, and a radius of ten (10) miles from their limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the city of Hull and the town of Buckingham, and a radius of ten (10) miles from their limits, rendered obligatory by the decree number 2246 of August 27, 1941, as amended by Orders 2918 of November 3, 1941, 1576 and 1745 of July 2 and 24, 1942, 441 and 3019 of February 19 and Ôctobrer 21, 1943, 2549 of July 6, 1945, 2850, 4466 and 4791 of July 17, October 31 and November^, 1946, 493-E of March 21, 1947, 245-A, 422-F and 912-E of February 26, March 30 and June 16, 1948, 625-C of May 31, 1950 and 541-E'of May 30, 1951, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 5, 1952; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; Be it enacted, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 2246, be amended as follows: 1.Subsection 6 of section HI-A is replaced by the following: \"6) Vacation with pay: Every female employee shall receive, each year, as vacation pay, an amount equivalent to 2% of the basic wages earned.In the event of an employee leaving her employer before the completion of 12 months service, she is entitled to a remuneration equivalent to 2% of the basic wages earned to date.\" 2.Sugsection \"e\" of section IV is replaced by the following: \"e) Vacation with pay: Every employee shall receive, each year, as vacation pay, an amount equivalent to 2% of the basic wages earned.In the event of an employee leaving his employer before the completion of 12 months service, he is entitled to a remuneration equivalent to 2% of the basic wages earned to date.\" 3.\"Le Syndicat des Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses du District de Hull\" is substituted, as contracting party of the first part, for \"L'Association des Maîtres-Barbiers du District de Hull\" and \"L'Association des Coiffeuses de la Cité de Hull.\" (Document \"C\" annexed to the Order) A.MORISSET, 32624-0 Clerk of the Executive Council.Avis divers Miscellaneous Notices L.Cohen & Son Lld.Règlement No 25 L.Cohen & Son Ltd.By-Law No.25 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, Be it enacted, and it is hereby enacted as a décrété comme règlement de la compagnie \"L.By-law of L.Cohen & Son Ltd., as follows: Cohen & Son Ltd.\", ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compa- 1.The number of the board of directors of gnie soit et il est, par les présentes, augmenté de the Company be, and it is hereby increased from trois (3) à cinq (5); three (3) to five (5); QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May tith, 195*, Vol.84, No.SI 1367 2.Que lei règlements de la compagnie soient \u2022t ils sont, par les présentes, modifiés pour \u2022\u2022 conformer au précédent.Le Secrétaire, 32625 E.BERNARD RTJBLN.Strategic Metals Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Règlement spécial \"C\" (Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs de la compagnie.) Le nombre des directeurs de la compagnie est, par les présentes, augmenté de trois à dix.A Montréal, ce 8e jour de mai 1952.Certifié vraie copie.(Sceau) Le Secrétaire, 32635 W.F.MACKLAIER.New Peninsular Oil Limited (Libre de responsabilité personnelle) Qu'il soit et il est par les présentes décrété comme règlement de la compagnie \"New Peninsular Oil Limited (Libre de responsabilité personnelle), ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de cinq à sept, de manière à ce que le bureau des directeurs de la compagnie sera dorénavant composé de sept directeurs.2.Trois directeurs formeront un quorum à toute assemblée du bureau des directeurs.Le 13 mai 1952.Certifié vraie copie.Le Président, 32639 ' LOUIS D.HUDON.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Petit Saguenay\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 16 mai 1952.: Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Petit Saguenay, Comté de Chicoutimi Le Sous-secrétaire de la Province, 32640-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de S-tAlphonse\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 16 mai 1952.Le siège social dû syndicat professionnel précité est situé à St-Alphonse de Caplan, comté de Bo-naventure.Le Sous-secrétaire de la Province, 32641-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif^'Syndicat Coopératif de 2.The By-laws of the Company be, and they they are hereby amended to accord with the fore* going.e.BERNARD RUBIN.82625-0 Secretary.Strategic Metals Ltd.(No Personal Liability).Special By-Law \"C\" (A By-law to increase the number of Directors of the Company).The number of Directors of the Company is hereby increased from three to ten.At Montreal this 8th day of May, 1952.Certified a true copy.(Seal) VV.F.MACKLAIER.32635-0 Secretary.New Peninsular Oil Limited (No Personal Liability) Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of New Peninsular Oil Limited (No Personal Liability) as follows: 1.The number of directors of the Company be and the same is hereby increased from five to seven so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of seven directors.2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.Certified a true copy.May 13th, 1952.LOUIS D.HUDON, 32639-0 President.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C C.de Petit Saguenay\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on May 16, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at Petit Saguenay, county of Chicoutimi.JEAN BRUCHÉSI, 32640 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Alphonse\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 16, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at St-Alphonse de Caplan, county of Bonaventure.JEAN BRUCHÉSI, 32641 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat 1368 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 mai 1952, Tome 84, N° 21 Construction de Malartic\", en date du 15 avril 1952, dont le siège social est situé à Malartic, dans le comté d'Abitibi, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 21 mai 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32654-0 JEAN BRUCHÉSI.Société internationale de recherches économique inc.International Economic Research Corporation inc.Règlement N° XXIII Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de cinq directeurs dont trois formeront quorum.Copie conforme.Montréal, ce 15 mai 1952.Le Secrétaire, 32645-0 C.-E.DOUVILLE.D.Cameron & Son Incorporated Règlement No.23 (Un règlement augmentant le nombre des des directeurs et le quorum pour les assemblées des directeurs.) 1.Règlement N° 3 (a) est, par les présentes, révoqué et remplacé par le suivant: \"3a.Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de cinq directeurs, chacun desquels au temps de son élection et pendant toute la durée de son terme d'office sera un actionnaire de la compagnie au montant d'au moins une action et n'aura pas d'arrérages concernant tout appel sur icellc.\" 2.Règlement N° 3 (e) est présentement révoqué et remplacé par le suivant: \"3e.Trois directeurs formeront un quorum pour les transactions d'affaires.Aucune résolution ou action du bureau des directeurs ne sera adoptée ni ne sera effective sans l'accord d'au moins trois directeurs.Les assemblées des directeurs peuvent être tenues en n'importe quel endroit et si tous les directeurs sont présents ou si un direc-teur absent a signifié son adhésion, aucun avis officiel ne sera nécessaire.\" Le 16e jour d'avril 1952.(Sceau) (Signé) Le Secrétaire, HAROLD J.GATES.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, HAROLD J.GATES.\u2022 32647 AVIS '(Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat National Catholique, des Employés de Pièces et d'Acessoires d'Automobiles\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 2 mai 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à 555, Boulevard Charest, Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la Province, 32650-o JEAN BRUCHÉSI.Coopératif de Construction de Malartic\", under date the 15th day of April, 1952, whereof the head office is at Malartic, county of Abitibi, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Sccretarv, May 21, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32654 Under Secretary of the Province.Société internationale de recherches économique inc.International Economic Research Corporation inc.By-Law No.XXIII The affairs of the company will be managed by a board of five directors, three of whom will form a quorum.True copy.Montreal, Mav 15, 1952.C.E.DOUVILLE, 32645 Secretary.D.Cameron & Son Incorporated By-Law No.28 (A By-Law increasing the number of Directors and the quorum for Meetings of Directors.) 1.By-Law No.3(a) is hereby repealed and replaced by the following: \"3a.The affairs of the company shall be managed by a Board of Five Directors, each of whom at the time of his election and throughout the term of his office shall be a shareholder in the company, to the amount of at least one share and not in arears in respect of any call thereon.\" 2.By-Law No.3(c) is hereby repealed and replaced by the following: \"3c Three Directors shall form a quorum of the transaction of business.No resolution or action of the Board of Directors shall be adopted or be effective unless concurred in by at least three Directors.Directors' meetings may be held at any place, and no formal notice shall be necessary if all the Directors are present, or if the Director absent has signified his consent to such meeting.\" 16th day of April 1952.(Seal) (Sgd.) HAROLD J.GATES, Secretary.Certified to be a true extract.HAROLD J.GATES, Secretary.32647-0 NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat National Catholique des Employés de Pièces et d'Accessoiies d'Automobiles\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on May 2, 1952.The principal place of business of the said professional syudicate is at 555 Charest Boulevard, Quebec, judicial district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 32650 Under Secretary of the Pèovince. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Lth, 1952, Vol.81, No.21 1369 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat des Loisirs de Sainte-Clotilde\", en date du 28 novembre 1951, dont le siège social est situé à Ste-Clotilde, district d'Artliabaska, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 27 mars 1952., Le Sous-secrétaire de la Province, 32651-0 JEAN BRUCHÉSI.Sutherland Construction Company Sommaire du règlement \"E\" La compagnie n'ayant aucunes obligations, l'actif sera distribué au pro rata entre les actionnaires qui y ont ) années ou plus de service continu recevront deux semaines de vacance payées annuellement.La rémunération payable aux employés ayant droit à deux semaines de vacances annuellement sera basée sur une (1) journée de paye pour chaque vingt-cinq (25) jours de travail faits pendant l'année précédente.VIII.La convention s'applique et s'étend à tous les salariés même les employés temporaires qui ont travaillé au cours de la période mentionnée sur le rapport mensuel du Comité Paritaire.IX.Durée de la Convention: La présente convention sera valable à compter de la date de la publication dans la Gazette Officielle de Québec de l'arrêté ministériel l'ayant approuvée et rendue b) Every new employee is entitled to the holiday with pay as soon as he has ninety (90) days service prior to the holiday.c) Also, an employee absent through illness or accident is entitled to holidays with pay providing he has been in the service of the employer for at least ninety (90) days prior to a holiday.d) Every employee eligible for a holiday, unless absent because of illness or an accident, shall have worked the whole working day preceding and the whole working day following the holiday.e) An employee will be considered absent who does not report for work unless he has obtained written authorization giving the reasons for his absence, or unless he produces a doctor's certificate./) An employee on his regular holidays at the time of a holiday with pay is also entitled to the remuneration for such holiday in addition to his regular holidays pay.g) Each one of the above mentioned holidays may be changed by mutual agreement between employer and employees, with the approval of the Parity Committee.VII.Vacation with pay: a) All employees who, on .May 1st of each year, have been in the service of their employer for one year, without interruption, shall benefit by a vacation of one week with pay.Such vacation is payable before the employee's vacation.Employment is interrupted by unauthorized absenteeism, discharge for cause, voluntary resignation or any other voluntary separation.Periods of disability caused through accidents as recognized by the Workmen's Compensation Hoard suffered during the course of employment, temporary lay-offs resulting from curtailed operations, or other causes beyond the control of the employee will be considered as time worked for the purpose of qualifying for vacation.No employee shall have the privilege of taking his vacation pay and continuing to work in lieu of taking his vacation, nor shall he have the right of engaging in any gainful occupation during his vacation period.Vacations due in any calendar year must be taken during that year and cannot be accumulated from year to year.b) Vacation pay will be computed on the basis of one half day's pay for each twenty-five days worked, at the regular rate of the employee's assigned function, and shall not be computed on the basis of overtime or of any rate that he might have received temporarily.c) Employees with five (5) or more years of continuous service shall have two weeks vacation per year.Vacation pay for employees entitled to two (2) weeks' annual vacation will be paid at the rale of one (1) day's pay for each twenty-five (25) days worked during the previous year.VIII.The agreement applies and extends to all employees, even temporary employees, who have worked during the period covered by the monthly report of the Parity Committee.IX.Duration of the agreement: The present agreement will come into force on the date of publication in the Quebec Official Gazette of the Order in Council rendering it obligatory and will QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SAth, 1968, Vol.84, No.St 1383 obligatoire et demeurera en vigueur pendant une période d'un (1) an à compter de cette date.Elle se renouvellera automatiquement d'année en année, à moins «pie l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis par écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant son expiration originale ou avant l'expiration de toute année subséquente.Un tel avis doit être également adressé au Ministre du Travail.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMRLAY.Ministère du Travail, Québec, le 24 mai 1952.32624 remain in force for a period of one (1) year from that date.It will then renew itself automatically from year to year unless either contracting party notifies the other party, in writing, to the contrary within the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day before its original expiration or before the expiration of any subsequent year.Such a notice shall also be filed with the Minister of Labour.During the thirty days folowing the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GERARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec.May 21, 1952.32624-o Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OF LAURENTIDES Candidat pour l'examen d'ordre théorique \u2014(36mo année) Candidate tor the examination op theorical order\u2014 (3rd Grade) Examcnx de juin 1052 \u2014 Examination* of June, l'J.ri2 Nom\tPrénom\tArc\tResidence Name\tSurname\tAge\tResidence Joly.\tCharles-André.\t25\tJolietto.\t\t\t Joliette, 15 niai 1952 \u2014 Jolicttu, May 15th, l!)52.312(531-2 l-2-o Le Secrétaire du Barreau des Lauren tides, MAURICE MAJEAU, Secretary of the Bar of Laurcntides.BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OF LATJRENTIDES Candidat pour l'examen d'ordre pratique (4èmc année) Candidate for the examination ok practical order (4th Crade) Examens de juin 1962 \u2014'Examinations of June, 1052 \tNom\t\tPrénom\tArc\tResidence \tName\t\tSurname\tAge\tResidcnco \t\tClaude.\t\t23\tJoliette.\t\t\t\t\t Joliette, 15 mai 1952 \u2014 Joliette, May 15th, 1952.32631-2 l-2-o Lettres patentes Rex Film Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des évêques catholiques romains (14 George VI.chapitre 76), il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du 13 mai 1952, constituant en corporation \"Rcx Film Inc.\" conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée.Le Secrétaire du Barreau des Luurentides, MAURICE MAJEAU.Secretary of the Bar of Laurent id en.Letters Patent Rex Film Inc.Notice is hereby given that under the provisions of the Roman Catholic Bishops Act (14 George VI, chapter 76), letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the 13th day of May, 1952, incorporating: \"Rex Film Inc.\", under the provisions of section 20 of the aforesaid Act. 1384 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 mai 1952, Tome 84, N° 21 Le siège social de ladite corporation est situé en la cité de Québec, province de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 21 mai 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32655-0 JEAN BRUCHÉSI.The corporate seat of the said corporation is in the City of Quebec, Province of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1952.JEAN BRUCHESI, 32655 Under Secretary of the Province.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Afco Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes supplémentaires en date du «S avril 1952, à la compagnie \"Afco Ltd.\", ratifiant le règlement spécial \"A\" étendant ses pouvoirs et objets à tels autres indiqués dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général le 8 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32623-q L.DÊSILETS.Afco Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act.chapter 276, R.S.Q., 1941, to the company \"Afco Ltd.\", ratifying special by-law \"A\" extending its powers and purposes to those indicated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, April 8, 1952.L.1) LSI LETS, 32623 Deputy Attorney General.An ( ! usii in n Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, R.S.Q.1941, chapitre 276.des lettres patentes supplémentaires, en date du 10 avril 1952, changeant le nom de la compagnie \"Anacon Extension Limited\" (No Personal Liability), constituée en corporation par lettres patentes, en date du 28 septembre 1950, en celui «le \"An-thonian Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability).Daté du bureau du Procureur général le 10 avril 1952.L'Assistant-procureur général.32023-o L.DÊSILETS.Urni'don Furniture Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Qi.ébec des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 1er avril 1952, changeant le nom de la compagnie \"G Granger Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 19 juillet 19-14 sous le nom de \"Gaston Granger et Compagnie Limitée\" \u2014 Gaston Granger and Company Limited\", en celui de \"Brandon Furniture Inc.\" Daté du bureau du Procureur général le 1er avril 1952.L'Assistmt-procureur général, 32623-0 L.DÊSILETS.Qucmaquc Explorers Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, supplémentaires en date du 14 avril 1952, Anthonian Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, changing the name of the company \"Anacon Extension Limited\" (No Personal Liability), incorporated by letters patent, dated September 28, 1950, into that of \"Anthonian Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, April 10, 1952.L.DÊSILETS, 32623 Deputy Attorney General.Brandon Furniture Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary let-ctrs patent, bearing date the first of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"G.Granger Inc.\" incorporated by letters patent dated July 19, 1944, under the name of \"Gaston Granger et Compagnie Limitée\" \u2014 \"Gaston Granger and Company Limited\", to that of \"Brandon Furniture Inc.\" Dated at the office of the Attorney General, this 1st day of April, 1952.L.DÊSILETS, 32623 Deputy Attorney General.Qucmaquc Explorers Ltd.(No personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Mining Companies' Act, and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the fourteenth day of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 24th, 1952, Vol.84, No.21 1385 changeant le nom de la compagnie \"Quemaque Gold Mines Limited\" (No Personal Liability constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, le 12 février 1947, en celui de \"Quemaque Explorers Ltd.\" (No Personal Liability), _Daté du bureau du Procureur général le 14 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32623-0 L.DÊSILETS.Ruby Foo's Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 avril 1952, à la compagnie \"Ruby Foo's Incorporated\", ratifiant: 1° \u2014 son règlement no 12 réduisant son capital-actions de 820,000 à 84,000 par l'annulation de 1600 action ordinaires de 810 chacune: 2° \u2014 son règlement no 13 portant sou capital-actions de 84,000 à 8300.000 par la création de 1600 actions ordinaires additionnelles de 810 chacune et de 2800 actions privilégiées nouvelles de 8100 sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général le 19 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32623-o L.DÊSILETS.the name of the company \"Quemaque Gold Mines Limited\" (No personal Liability), incorporated under the provisions of the Quebec Mining Companies Act, by letters patent dated February 17, 1947, to that of \"Quemaque Explorers Ltd.\" (No personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, this 14th day of April, 1952.L.DÊSILETS, 32623 Deputy Attorney General.Ruby Foo's Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Ruby Foo's Incorporated\", ratifying: 1.its By-law No.12 reducing its capital\" stock from 820,000 to 84,000 by the cancellation of 1600 common shares of 810 each; 2.its By-law No 13 increasing its capital stock from $4,000 to 8300.000 by the creation of 1600 additional common shares of 810 each and 2800 new preferred shares of 8100 shares of 8100 subject to the rights and restrictions indicated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, April 19, 1952.L.DÊSILETS, 32623 Deputy Attorney General.Ministère des Finances Assurances Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que \"The Insurance Corporation of Ireland Limited\", enegistrée sous le numéro 523, a obtenu le permis et certificat d'enregistrement numéro 545 qui l'autorise, à compter du 28 décembre 1951, à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Incendie et accessoirement \u2014 agitation civile, choc de véhicules, chute d'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, explosion limitée ou inhérente, fuite d'eau, .»rêlc limitée, ouragan, tremblement de terre; Accident; Automobile; Biens mobiliers; Bris de glace; Garantie; Responsabilité civile; Responsabilité de l'employeur; Transport intérieur; Vol.Le siège social de la compagnie est situé à Dublin, Irlande.La compagnie a nommé M.Raoul A.Beaudry, 485 rue McGill, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des Finances, le 9 mai 1952.Pour le Ministre des Finances de la Province GEORGES LAFRANCE 32592-20-2-o Surintendant des assurances Department of Finance Insurances Notice of Issue of Licen.se and Certificate ok Registration Notice is hereby given that \"The Insurance Corporation of Ireland Limited\", registered under number 523, has obtained the license and certificate of registration number 523, has obtained the license and certificate of registration number 545 authorizing it, as from the 28th of December 1951, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Fire, and supplementary thereto \u2014 civil commotion, earthquake, falling aircraft, impact by véhicules, limited hail, limited or inherent explosion, springkler leakage, water damage, windstorm; Accident; Automobile; Employers' liability; Guarantee; Inland transportation; Personal property; Plate glass; Public liability; Theft.The head office of the company is situate at Dublin, Ireland.The company has appointed Mr.Raoul A.Beaudry, 485 McGill Street, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 9th of May, 1952.For the Minister of Finance of the Province GEORGES LAFRANCE 32592-20-2-o Superintendant of Insurance Sièges sociaux Gatineau Power Company \"Règlement Special \"R\" (Changement du siège social) La principale place d'affaires de la compagnie Head Offices Gatineau Power Company \"Special By-Law \"R\" (Changing Head Office) The Chief place of.business of the Company 1380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A mai 1952, Tome SA, A° 21 est, par les présentes, changée «le la cité de Mont- is hereby changed from the City of Montreal to real à la cité de Hull, dans la privince de Québec, the City of Hull, in the Province of Quebec.TT-.ii i» rv i.oe .:» inert tt.ii i> r\\ k____:i c,- irv=r» Hull, P.Q.Ic25 avril 1952.Certifié vraie copie.32030 Le Secrétaire, .1.R.HINKS.Hull.P.Q.April 25, 1952.Certified true Copy: 32030-o J.R.BINKS, Secretary.sociktk internationale uk recherches économique inc.International Economic Research Corporation Inc.Avis est donné que la \"Société Internationale de Recherches Économique Inc.\u2014 \"International Economic Research Corporation inc.,\" constituée en corporation par lettres patentes, en date du 8 juin 1949, et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, 132 ouest, rue St-Jacqucs, aura, à compter du 20 niai 1952, son siège social au numéro 2101, Ave Bennett, en ladite cité de Montréal.Montréal, ce 15 mai 1952.Le Secrétaire, 32640-o C.E.DOUVILLE.Société internationale de recherches économique inc.International Economic Reciiearcii Corporation inc.Notice is hereby given that the \"Société Internationale de Recherches Economique Inc.\" \u2014 International Economie Research Corporation Inc., incorporated by letters patent, dated June 8, 1949, and having its head office in the city of Montreal, at 132 St.James street, West, will have, as from the 26th of May, 1952, its head office at No.2101 Bennett Avenue, in the said city of Montreal.Montreal, May 15, 1952.C.E.DOUVILLE, 32646 Secretary.Soumissions Tenders Province de Québec Commission Scolaire du village de MiSTASSINI (Comté de Roberval) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, E.Tremblay, sec.-très.Mistassini, comté de Roberval, jusqu'à 7 heures P.M., lundi le 9 juin 1952 pour l'achat de 8332,000.d'obligations de la commission scolaire du village de Mistassini, comté de Roberval, datées du 1er mai 1952 et remboursables par séries du 1er mai 1953 au 1er mai 1907 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 4}4% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $33 Année 1er mai 1953.1er mai 1954.1er mai 1955.1er mai 1956.1er mai 1957.1er mai 1958.1er mai 1959.1er mai 1960.1er mai 1961.1er mai 1962.1er mai 1963.1er mai 1964.1er mai 1965.1er mai 1966.1er mai 1967.2,000.00 \u201415 ans.Capital 846,500.00 48,500.00 50,500.00 53,000.00 55,500.00 6,500.00 6,500.00 7,000.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00 Province of Quebec School commission ok the village ok Mistassini (County of Roberval) Public notice is hereby k'ivcii that sealed tenders, endorsed \"Tenders lor bonds*' will be received by the undersigned, E.Tremblay, sec-treas., Mistassini, county of Roberval, until 7 o'clock P.M., Monday the 9th clay of June, 1952, for the purchase of an issue of 8332.000 of bonds of the School ('omission of the Village of Mistassini.county Roberval, dated the 1st of May, 1952.and redeemable serially from May 1, 1953 to May, 1, 1907, unclusively, with interest at a rate of 4)4% per annum, payable semiannually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table ôf redemption \u2014 Year 1st May 1953.1st May 1954.1st May 1955.1st May 1950.1st May 1957.1st May 1958.1st May 1959.1st Mav 1960.1st May 1961.1st May 1962.1st May 1963.1st Mav 1964.1st Mav 1965.1st Mav 1966.1st Mav 1967.332 ,000 \u2014 16 Capital x §46,500.00 x 48,500.00 x 50,500.00 x 53,000.00 x 55,500.00 0,500.00 6,500.00 7,000.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00 years Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles The letters \"x\" indicate the years during which les versements annuels d'un octroi total de 8257, annual payments of a total amount of S257.592.60 592.60 accordé par le Secrétaire de la Province granted by the Provincial Secretary and payable et payable en cinq versements de 851,518.52 de in five instalments of 851,518.52 from 1953 to 1953 à 1957 inclusivement, seront reçues et appli- 1957 inclusively, will be received and applied qués au service de l'emprunt.to the service of this loan. QUEBEC OFFICIAL OAZETTE, Quebec, May 21th, 1962, Vol 84, No.21 1387 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentlionné dans la'pro-cédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Dolbeau.Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'uu chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 9 juin 1952 à 7 heures P.M., à la salle municipale du Centre Social à Mistassini, comté de Roberval.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mistassini (Comté de Roberval), ce 19 mai 1952.Le Secrétaire-trésorier, Mistassini, E.TREMBLAY.(Roberval).32642-0 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Dolbeau.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par.at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on the Monday, 9th day of the month of June, 1952, at 7 o'clock P.M., at the Municipal Hall of the \"Centre Social\" at Mistassini, county of Roberval.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Mistassini (County of Roberval) this 19th dav of May, 1952.E.TREMBLAY, M istassini, Secretary-Treasurer.(Roberval).32642 Vente \u2014 Loi de faillite .Canada Province de Québec.Cour Supérieure district de Rimouski, (siégeant, en matière de faillite).No.13,673 Philippe Pelletier, Esprit-Saint, Cté Rimouski, district de Rimouski, failli, et Henri-A.Martin, Syndic.Avis public est par le présent donné que les terres et héritages sous mentionnés seront vendus aux temps et lieu respectifs, tel que mentionné plus bas.* a) Partie, du numéro vingt-deux (P.22) du premier rang du Canton Laroche, étant un terrain situé dans la paroisse d'Esprit-Saint, mesurant deux cent quarante (240) pieds de front, est et ouest, dans le sens du chemin, sur deux cent soixante pieds (260) de profondeur, nord et sud, dans le sens de la route, le tout, mesure anglaise, borné au nord et à l'ouest, à Jules Cimon; au sud, au chemin de front; à l'est, à la route, avec le moulin à scier et débiter le bois comprenant toutes les machines, la machinerie, les appareils et accessoires, etc., et toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.b) Partie, du numéro vingt-trois (P.23) du deuxième rang du dit Canton Laroche, avec la maison en bois de deux étages construite sur le dit terrain qui mesure cinquante pices (50) de front, direction est et ouest par cent pieds (100) de profondeur, direction nord et sud, mesure anglaise et qui est borné comme suit: au nord, au chemin ; au sud, au vendeur, Irénée Lizotte, au reste du lot; à l'est à Turibe Fournier; à l'ouest, à Léo Lizotte, circonstances et dépendances.Pour être vendues au bureau du Syndic soussigné à Rimouski, le QUATRIÈME jour de JUIN 1952, à DIX heures de l'avant-midi (heure avancée).Cette vente aura le même effet qu'une vente faite par le shérif.Le Syndic Licenciée, HENRI-A.MARTIN.Bureau: 152A, de l'Evêché, Rimouski, P.Q.32502-18-2-o Sale \u2014 Bankrupcy Act Canada, Province of Quebec, Superior Court' district of Rimouski.sitting in bankruptcy.No 13673.Philippe Pelletier, Esprit-Saint, Cté Rimouski, district of Rimouski, Bankrupt, & Henri A.Martin, Trustee.Public notice, is hereby given that the under mentioned lands and tenements will be sold at the respective time and place mentioned below.a) Part of number twenty-two (Pt.22) of the first range in the township of Laroche, being a lot of land situate in the parish of Esprit-Saint, measuring two hundred and forty (240) feet in front, east and west, in the direction of the highway, by two hundred and sixty feet (260) in depth, north and south, in the direction of the road, the whole, English measure, bounded on the north and on the west, by Jules Cimon; on the south, by the highway in front; on the East, by the road, with the mill which saws and cuts wood, comprising all the machines, machinery, appliances and dependencies.b) Part of number twenty-three (Pt.23) of the second range of the said township of Laroche, with the two-storey wooden house erected on the said land which measure fifty feet (50) in front, east and west direction, by one hundred feet (100) in depth, north and south direction, English measure and which is bounded as follows: on the north, by the highway: on the south, by the vendor, Irénée Lizotte, by the rest of the lot; on the east, by Turibe Fournier; on the west, by Léo Lizotte, circumstances and dependencies.To be sold at the office of the undersigned Trustee, at Rimouski, the FOURTH DAY of JUNE, 1952, at TEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving-time).This sale shall have the same effect as a sheriff's sale.HENRI A.MARTIN, Licenced Trustee.Office: 152A, de l'Evêché, Rimouski, P.Q.32502-18-2 1388 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 mai 1952, Tome 84, N° 21 Province de Québec \u2014 District de Chicoutimi Commission scolaire de Canton Bourget Avis public est, par les présentes donné que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du cinq mai 1952, a dordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes ducs aux commissaires d'écoles pour la municipalité du canton Bourget, à la corporation municipale de St-Am-broise, ainsi que les répartitions dues à la corporation des Syndics de la Paroisse de St-Ambroise, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence, les dits immeubles seront vendus par encan public, dans le bureau du secrétaire-trésorier, Arthur-E.Asselin, lieu ordinaire des séances de la commission scolaire de canton Bourget, à St-Ambroise, le onze juin 1952, à 11 heures de l'avant-midi, heure avancée.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes scolaires et municipales et les répartitions de l'église échues le ou avant le 30 juin 1951, auront été payées, avec les frais, avant le moment de la vente.1.Succession Ludger Gagnon \u2014 Lo lot 14.rang 1, sous réserve des droits do Prii-.cs Brothers Company Limited, Aluminum Company of Canada Limited, Saguenay Transmission Company Limitod et la Compagnie Electrique du Saguonay, leurs représentants ou sucesseurs, suivant actes enregistrés.2.Adélard Gannon \u2014 a) La dainie nord du lot 10, ran?Ouest, bornée: au nord par la ligne de division des lots 10 et 11 ; à l'est, par la rivière des Aulnaies; au sud, gar lo résidu du dit lot 10 ot à l'ouest, par le rang uest 2.b) La demie sud du lot 11, partie aussi appelée 11-A, rang Ouest, bornéo: au nord, par lo terrain de J.B.llacino ou ropr^snetants; h l'est, par la rivière des Aulnaies; au sud, par la ligne de division des lots 10 et 11 ot n l'ouest, p:ir une ligne parallèle aù cordon en profondeur du dit rang et distante de 15 arpents à l'est d'icelui, sous réserve des droits do la Compagnie Electrique du Saguenay.3.Edmond Michaud \u2014 a) Partie ouest du lot 14, rang C, bornée comme suit: au nord, par la ligne de séparation des lots 14 et 15; à l'est, par le terrain do Louis-Honri Gagné ou représentants; au sud, par la ligne do séparation des lots 13 ot 14 et à l'ouest, par le chemin public séparant les rangs C et D.6) Partie Ouest du lot 15, rang C, bornéo comme suit: au nord, par la ligne do séparation des lots 15 et 16; à l'est, par le terrain de Louis-Henri Gagné ou représentants; au sud, pnr la ligne de séparation des lots 14 et 15 et à l'ouest, par le chemin public séparant les lots C et D.4.Edmond Michaud.\u2014 Le lot 1, rang B.ô.Adrien Flamand \u2014 a) Partie Nord du lot 19, rang Est, mesurant environ 62 acres et % en superficie, bornée: au nord, par la ligne de division des lots 19 et 20; à l'est, par le canton Simard; au sud, par la partie sud du dit lot 19 appartenant à Louis-Henri Tremblay ou représentants, et à l'ouest, par la rivière des Aulnaies.b) Lo lot 20, rang Est, d'une superficie approximative de 132 acres, bous réserve dos emplacements vendus, tels que clôturés actuellement, occupés par Louis Simard, Paul Savard, Joseph Tremblay, Joseph Fortin, Epiphano Fortin, Alfred Tremblay, Henri Duperré, Philippe Lavoie, Ernest Tremblay, Nérée Bouchard, Henri Duperré ou leurs représentants ou successuers, et sous réserve également des droits de Price Brothers and Company Limitod et do Saguenay Transmission Company Limited, pour lignes de transmission ainsi que terrain occupé pour une sous station électrique par la compagnie Saguenay Transmission.Les dits lots ou parties do lots ci-dessus sont du cadastre officiel du canton Bourget.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Us seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en à, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes pouvant les affecter.Province of Quebec \u2014 District of Chicoutimi School Commission ok the Township Bourget Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the fifth of May, 1952, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1941, chapter 207), to sell the immovables herein-below described, in payment of arrears of taxes due to the school commissioners for the Municipality of the Township Bourget, to the municipal corporation of St-Ambroise, and also the apportionment due the corporation of Trustees of the Parish of St-Ambroise, with interest and costs, and that consequently, the said immovables will be sold by pub.vc auction, in the office of the Secretary-Treasurer, Arthur E.Asselin, in the usual meeting place of the school commission of the township Bourget.at St-Ambroise, on the eleventh day of June, 1952, at eleven o'clock in the forenoon (Daylihgt Saving Time).However, there will be excluded from the sale, those immovables whereon the school and municipal taxes and the church apportionments due on or before the 30th of June, 1951, shall have been paid, with costs, before the sale.1.Estate Ludger Gagnon: \u2014 Lot 14, range 1.undor reserve of the rights of Price Brothers Company Limited, Aluminum Company of Canada, Saguonay Transmission Company Limited and the \"Compagnie Electrique du Saguenay\", their representatives or successors, according to registered deeds.2.Adélard Gagnon: \u2014 a) The north half of lot 10, West range, bounded: on the north by the division line of lots 10 and 11; on the east, by the des Aulnaies river, on the south by the residue of said lot 10 and on the west, by West rango 2.b) The south half of lot 11, the part also called 11-A West range, bounded: on the north, by the land of J.B.Racine or representatives; on the oast, by the des Aulnaies river; on the south, by the division lino of lots 10 and 11 and on the west, by a line parallel to the '.'cordon\" at the depth of the said range and distant 15 arpents to the east therefrom, under reserve of the rights of the \"Compagnie Electrique du, Saguenay\".3.Edmond Michaud: \u2014 a) The west part of lot 14, range C, boundod as follows: on the north, by the division line of lots 14 and 15; on the cast, by the land of Louis Henri Gagné or representatives; on the south, by the division line of lots 13 and 14 and on the west, by the public road separating ranges C and D.6) The west part of lot 15, range C, bounded as follows: on the north, by the division lino of lots 15 and 16, on the oast, by the land of Louis Henri Gagné or representatives; on the south, by the division line of lots 14 and 15 and on the west, by the public road separating lots C and D.4.Edmond Michaud: Lot 1, range B.5.Adrien Flamand: \u2014 a) North part of lot 19, East rango, measuring about 62 acres and J$ in superficial area, boundod.on the north, by the- division line of lots 19 and 20; on tho east, by the township Simard; on the south, by the south part of said lot 19 belonging to Louis Henri Tremblay or representatives, and on tho west, by the des Aulnaies river.b) Lot 20, East range, of an approximative area of 132 acres, under reserve of the emplacements sold, as actually fenced in, occupied by Louis Simard, Paul Savard, Joseph Tremblay, Joseph Fortin, Epiphane Fortin.Alfred Tremblay, Henri Duperré, Philippe Lavoie, Ernest Tremblay, Nérée Bouchard, Henri Duperré or their representatives or successors, and under reserve also of the rights of Price Brothers and Company Limited and the Saguenay Transmission \"Company Limited, for transmission lines and also the land occupied for an electric sub-station by tho Saguenay Transmission Company.The said lots or parts of lots hereinabove described are of the official cadastre for the township Bourget.The purchase price of each of the said immovables will be payable immediately.They will be sold with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any, and with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes affecting the same.Vente pour taxes Sale for Taxes QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec: May 2Âth, 1952, Vol.81, No.21 1389 La vente sera en outre sujette au droit de rc- The sale shall, moreover, be subject to right trait et aux autres dispositions de la Loi de la of redemption and to the other provisions of the Commission municipale de Quebec.Quebec Municipal Commission Act.Donné à St-Ambroise de Chicoutimi, ce lième Given at St-Ambroise de Chicoutimi, this 12th jour du mois de mai 1952.day of the month of May, 1952.Le Secrétaire-trésorier, ART.E.ASSEL1N, 32593-20-2-o ART.E.ASSELIN.32593-20-2 Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHERIF AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mcntionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.GASPÉ Fieri Facias de Terris Province de Québec \u2014 District de Gaspé Cour Supérieure, é\"D L.DIMOCK, garagiste, Percé, P.Q., ) Lv« de Sandy Beach, comté N° 3398.) et district de Gaspé, demandeur, \\s ULDEGE DESPFÊ, journalier, de Rivière au Renard, comté de Gaspé, P.Q., défendeur.\"Une certaine partie ou parcelle de terrain située dans la municipalité de Rivière au Renan! connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Fox, comme étant le lot N° 18 de l'arpentage primitif, maintenant connue comme étant les lots 121-4, 126-6, 126-7 et 128 du rang sud de la rivière, canton de Fox, comté de Gaspé.Pour être vendue à la porte de l'église du village de Rivière au Renard, le SIXIEME jour de JUIN 1952, à DIX heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, M.J.FURI.ONG.Percé P.Q., 26 avril 1952.32500-18-2 HULL District de Hull Cour de Magistrat, f T A Compagnie \"WEAR N° 325.< ^ EVER BRUSH COM-v PANY LIMITED\", un corps politique et inorporé, ayant ses siège social et principale place d'affaires en la cité deToronto, dans la province d'Ontario et une place d'affaires en les cité et district de Montréal, demanderesse; vs GISELE BILODEAU, des cité et district de Hull, fille majeure et LES HERITIERS DU DÉFI NT JOSEPH BILODEAU, de son vivant des cité et district de Hull, employé civil, défendeurs.\"Subdivision numéro trente et un du lot numéro neuf du quartier numéro trois (Q.III-9-31) aux plan et livre de renvoi officiels de la cité de Hull, ensemble avec tous édifices dessus érigés et ameliorations des'us faites et tous droits, membres et appartenances\".Pour être verdue au Bureau du Shérif, Palais de Justice, à Hull, le QUATRIEME jour de JUILLET, 1952, à DIX heures de l'avant-midi (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, J.ST-PIERRE.19imai, 1952.32644-21-2 KAMOURASKA Fieri, Facias de Terris Canada, Province de Québec District de Kamouraska N° 18076 ( TLTERVÉ D'AUTEUIL, employé, de | il Trois-Pistoles, Co.Rivière-du- SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentiuned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.GASPÉ Fieri Facias de Terris Province of Quebec \u2014 District of Gaspé Superior Court, /\"D L.DIMOCK, Garage Percé, P.Q., ) Lv.owner of Sandy Beach, N° 339S.J county and District of Gaspé; (plaintiff: vs ULDEGE DES-PRE, labourer of Rivière au Renard, County of Gaspé, P.Q.defendant.\"A certain piece or parcel of land situate in the Municipality of Fox River, County of Gaspé, known and designated on the Official Plan and in the Book of Reference of the Township of Fox, as primitif lot No.18, of the primitif survey, now known as lots 124-4, 126-6, 126-7 and 128 of the range South of the River, Township of Fox, County of Gaspe.To be sold at the church door of the Village of Rivière Au Renard on the SIXTH day of JUNE 1952 at TEN o'clock in the forenoon.M.J.FURLONG, Sherifi's Office, Sheriff.Percé, P.Q.April 26th 1952 32500-18-2-n HULL District of Hull Magistrate's Court (\\\\ /EAR EVER BRUSH No.325.-j W COMPANY LIM-\\ ITED, a body politic and corporate, having its Head Office and principal place of business in the City of Toronto, in the province of Ontario and a place of business in the City and District of Montreal, plaintiff, vs GISELE BILODEAU, of the City and District of Hull, spinster of the age of majority and THE HEIRS OF THE LATE JOSEPH BILODEAU, in his lifetime of the City and District of Hull, Civil Employee, defendants.\"Subdivision number thirty-one of lot number nine of Ward number three (W.111-9-31) on the Official Plan and Book of Reference for the City of Hull, together with all buildings thereon erected and improvements thereon made and all rights, members and appurtenances.\" To be sold at the Sheriff's Office.Court House, at Hull, on the FOURTH day of JULY, 1952, at TEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).I.ST-FIERRE, Sheriff's Office, Sheriff.May 19, 1952.32644-21-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada, Province de Quebec, District de Kamouraska No.18076 j \"LJERVÉ D'AUTEUIL, employee, \\ *\u2022 * of Trois-Pistolcs, Co.of Rivière- 1390 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2U mai 1952, Tome 84, N° 21 Loup, demandeur; vs JEAN-MARIE MALENFANT, propriétaire d'hôtel, de Trois-Pistoles, Co.Rivière-du-Loup, défendeur.Un terrain situé au premier rang de la paroisse de Trois-Pistoles, dans la Ville, borné au sud à la rue dite Dames de la Congrégation, à l'ouest à Arthur Bélanger, à l'est à Arthur Boucher, au nord au terrain de la tannerie, lequel terrain fait partie du lot \\° ISO du cadastre de Trois-Pistoles, avec aussi toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Trois-Pistoles dans la Ville, LUNDI, le VINGT-TROISIEME jour de JUIN, 1952, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup.12 mai, 1952.32049-21-2-o [Première insertion, samedi le 24 mai, 1952] QUÉBEC Fieri Facias.Québec, à savoir: / T A.FORTIN, epicier-N®'65347 -\\J* boucher licencié, domi-v cilié à 14 rue Lacroix, La Tuque; contre ROLAND LAROUCHE, cultivateur, domicilié à La Bostonnais, comté de Lavio-lette, à savoir: Le lot No 14 (quatorze) étant un lot de terre situé dans le rang nord-ouest, du Canton Bourgeois, comté de Laviolettc, avec le moulin à scie et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de S!-.lean Bosco, comté de Laviolettc, le VINGT-SEPTIÈME jour de JUIN prochain, â DIX heures du malin.Le Shérif.Bureau du Shérif, AIMÉ.DION.Québec, le 19 mai 1952.32632-21-2-0 [Première insertion: 24 mai 1952.] Deuxième insertion:?juin 1952.] du Loup, plaintiff; vs JEAN-MARIE MALENFANT, hotel-keeper, of Trois-Pistoles, Co.- of Rivière-du-Loup, defendant.A lot of land situate in the first range of the parish of Trois-Pistoles, in the Town, bounded on the south by the street called \"Dames de la Congrégation, on the west by Arthur Bélanger, on the east by Arthur Boucher, on the north by the laud of the tannery, said lot of land forming part of lot No.ISO of the cadastre for Trois-Pistoles, together with all the buildings thereon erected.To be sold at the church door of the parish of Trois-Pistoles, in the Town, on MONDAY the TWENTY-THIRD day of JUNE, 1952, at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, May 12.1952.32049-21-2 [First insertion, Saturday, May 24, 1952] QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit: ( T A.FORTIN, licensed gro-No.65347 sj* ccr-buteber, domiciled at \\ 14 Lacroix Street, La Tuque; against ROLAND LAROUCHE, farmer, domiciled at La Bostonnais, county of Laviolettc, to wit: Lot No.14 (fourteen) being a lot of land situate in the northwest range of the township of Bourgeois, county of Laviolettc, with the sawmill and other buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parish church door of St-Jeaii Bosco, county of Laviolettc, the TWENTY-SEVENTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, Mav 19, 1952.32032-21-2 [First insertion: May 21.1952] [Second insertion: .June 7.1952].Fieri Facias.Québec, à savoi r : / T E CO MP T 01R D E No 02547 < *-> CRÉDIT, LIMTÉE, I corporation légalement constituée, ayant son siège social à Qiu'bec; contre GERARD AUGER, de St-Pierre de Charles-bourg, comté de Québec, vendeur et propriétaire, à savoir: 1.Le lot No 13 (treize) de la subdivision Nol (un) du lot No 417 (quatre cent dix-sept) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlcsbourg, comté de Québec, étant un emplacement situé sur la rue Létourneau, mesurant 01 pieds et 10 pouces de front sur 09 pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise.2.Partie du lot No 12 (douze) de la subdivision No 1 (un) du lot No 417 (quatre cent dix-sept) du cadastre officiel dour la paroisse de Charlcsbourg, comté de Québec, étant un terrain situé sur la rue Létourneau, mesurant 15 pieds de front sur 69 pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise, bornée au sud-ouest par le lot No 417-1-13, au sud-est par le lot No 416, au nord-est par le résidu du dit lot No 417-1-12 et au nord-ouest par la rue Létourneau.Le tout pour être vendu \"en bloc\" avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Avec droit de passage sur la lisière de 15 pieds constituant la continuation de la rue et étant une partie du lot No 417 non subdivisé.Fieri Facias Quebec, to wit : / T E C O M P T 01R D E No.62547 < -L* CRÉDIT, LIMITÉE, \\ a duly incorporated body, having its head office at Quebec; against GERARD AUGER, of St-Pierre de Charlcsbourg, county of Quebec, salesman and proprietor, to wit: 1.Lot No.13 (thirteen) of subdivision No.1 (one) of lot No.417 (four hundred and seventeen), of the official cadastre for the parish of Charles-bourg, county of Quebec, being an emplacement situate on Létourneau street, measuring 01 feet and 10 inches in front by 09 feet in depth, more or less, English measure.2.Part of lot No.12 (twelve) of subdivision No.1 (one) of lot No.417 (four hundred and seventeen) of the official cadastre for the parish of Charlesbourg, county of Quebec, being a lot of land situate on Létourneau street, measuring 15 feet in front by 69 feet in depth, more or less, English measure, bounded on the southwest by lot No.417-1-13, on the southeast, by lot No.416, on the northeast by the residue of said lot No.417-1-12 and on the northwest by Létourneau street.The whole to be sold \"en bloc\" \u2014 with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.With right of way over a strip of 15 feet constituting the continuation of the street and being a part of lot No.417 unsubdivided. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2Ath, 1952, Vol 8A, No.21 1391 Pour être vendus \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de Charlcsbourg, comté de Québec, le VINGT-SEPTIEME jour de JUIN prochain, à DTX heures du matin.Le Shérif.Bureau du Shérif.AIMÉ DION.Québec, le 19 mai 1952.32033-2 l-2-o |Première insertion: 24 mai 19f>2.] Deuxième insertion: 7 juin 1952.SAINT-FRANÇOIS Province de Québec, District de Saint-François, dans et pour le comté de Stanstead, à Coalicook Cour de Magistrat./ TYENÏS S.BÀCHAND, N° 0203. OSAIRE LECOURS, far-No.20090 < mer of village of Upton, (.county of Bagot, district of St-Hyacinthe, plaintiff; vs JEAN BAPTISTE CHARBONNEAU, of the parish of St-Louis of Terrebonne, district of Terrebonne, defendant, At the cadaster for the Parish of St-Louis de Terrebonne.St-François range, the lot 339 subdivisions 1 to 36, less the subdivisions 10.I 1 and 12, the lot 341 subdivisions lto 9, the lot 341 subdivision 13, to 00, the 342 subdivisions 1 to 102.the lot 343 subdivisions 1,2,7 to OS and pari .'535 and part 33S .actually in the possession of Jean Baptiste Charbonneau farmer of the Parish of St-Louis de Terrebonne as belonging to him.To be sold at the Catholic church door of the Parish of St-Louis do Terrebonne, on July the SECOND, 1952 at ELEVEN o'clock in the forenoon.ALB.FOURNELLE, Sheriff's Office, Sheriff for Terrebonne.St-Jérôme, May 15, 1952.32034-21-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N° 21 Arrêtés en Conseil: 550, section \"A\" \u2014 Construction, comtés de Joliette.etc.1360 550, section \"B\" \u2014 Commerce de quain- caillerie, etc., Québec.1303 Index of the Quebec Official Gazette, No.21 Orders in Council: 556, Part \"A\" \u2014 Construction, counties of Joliette, etc.1360 556, Part \"B\" \u2014 Hardware, etc., Quebec.1363 1392 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A mai 1952, Tome 84, N° 21 556, section \"C\" \u2014 Barbier, coiffeur et coiffeuse, Hull.Avis aux intéressés: Avis divers: 1).Cameron & Son Incorporated (Directeurs).L.Cohen & Son Ltd (Directeurs).Le Syndicat de l'U.C.C.de Caplan (Formation) .Le Syndicat de l'U.C.C.de Petit Saguenay (Formation).New Peninsular Oil Limited (Directeurs) .Société Internationale de Recherches Économique Inc.\u2014 International Economie Research Corporation Inc.(Directeurs).Strategic Metals Ltd (Règlement).Sutherland Construction Company (Dist.de l'actif).Syndicat Coopératif de Construction de Malartic (Fondation).Syndicat des Loisirs de Sainte-Clotilde (Fondation).Syndicat National Catholique des Employés de Pièces et Accessoires d'Automobiles (Formation).Chartes \u2014 Abandon de: Boston Textiles Inc.Hélène Martiu Inc.Niki Incorporation.Rosslin Improvement Company.Sutherland Construction Company .Suzorite Company Limited.Textile Marketing Service Incorporation.Compagnies dissoutes: A, & P.Dental Supply Inc.Fashion Fur Co.Polk Vaughan, Inc.Vogue Shopping ('entre Inc.'.Curatelle publique: Rivard, suce.Ulphie.DÉPARTEMENTS - AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Grondines, No 1, village.Kingsbury (protestants).Northfield ('entre (Protestants).Sacré-Cœur-de-Jésus.paroisse.St-Basile-Station.St-Ephrem-de-Fitch-Bay.St-Thomas.Val-St-Michel, ville.Travail: Industrie ou métiers de: Camionnage.région Trois-Rivières (Avis).Commerce de détail, Rock-Island, etc.Construction, comtés Abitibi-Est, etc.(Modification).Construction, Montréal (Règlements).556, Part \"C\" \u2014 Barber and hairdress- 1365 ing, Hull.1365 1359 Notice to Interested Parties: 1359 Miscellaneous Notices: D.Cameron & Son Incorporated (Di-1368 rectors).1368 1366 L.Cohen & Son Ltd (Directors).1366 Le Syndicat de l'U.C.C.de Caplan (For- 1367 mation).1367 Le Svndicat de l'U.C.C.de Petit Sa- 1367 guenay (Formation).1367 New Peninsular Oil Limited (Direc- 1367 tors).1367 Société Internationale de Recherches Économique Inc.\u2014 International Economie Research Corporation Inc.1368 (Directors).1368 1367 Strategic Metals Ltd (By-law).1367 Sutherland Construction Company 1369 (Dist.of assets).1369 Syndicat Coopératif de Construction 1367 de Malartic (Foundation).1367 Svndicat des Loisirs de Sainte-Clotilde 1369 (Foundation).1369 Syndicat National Catholique des Employés de Pièces et Accessoires d'Au- 1368 tomobiles (Formation).1368 Charters \u2014 Surrender of: 1369 Boston Textiles Inc.1369 1369 Hélène Martin Inc.1369 1369 Niki Incorporation.1369 1370 Rosslin Improvvement Company.1370 1370 Sutherland Construction Company.1370 1370 Suzorite Company Limited.1370 Textile Marketing Service Incorpora-1370 tion.1370 Companies Dissolved: 1370 A.& P.Dental Supply Inc.1370 1371 Fashion Fur Co.1371 1371 Polk Vaughan, Inc.1371 1371 Vogue Shopping Centre Inc.\u2022.1371 Public Curatorsiiip: 1371 Rivard, Estate Ulphie.1371 DEPARTMENTAL NOTICES: Education: School Municipality of: 1372 Grondines, No 1, village.1372 1372 Kingsbury (protestants).1372 1372 Northfield Centre (Protestants).1372 1372 Sacré-Cœur-de-Jésus, parish.1372 1373 St-Basile-Station.1373 1372 St-Ephrem-de-Fitch-Bay.1372 1373 St-Thomas.1373 1373 Val-St-Michel, town.1373 Labour: Industry or trades of: Cartage/ district of Trois-Rivières 1380 (Notice).1380 Retail trade.Rock Island, etc.(Notice) 1370 1370 Construction, counties of Abitibi-East 1374 (Amendment).1374 1375 Building, Montreal (By-laws) .\u2022.1375 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 2/tth, 1952, Vol 8À, No.21 1393 Examens du Barreau: Laurentides: étude du droit.Lettres patentes: Rex Film Inc.Lettres patentes supplémentaires: Afco Ltd.Anthonian Mining Corporation Ltd.Brandon Furniture Inc.Quemaque Explorers Ltd.Ruby Foo's Incorporated.Ministère des Finances: Assurances: The Insurance Corporation of Ireland Limited.Sièges sociaux: Gatincau Power Company.Société Internationale de Recherches Économique Inc.\u2014 International Economie Research Corporation Inc.Soumissions: Mistassini, Comm.scol.village.Vente, Loi de faillite: Pelletier, Philippe.Vente pour taxes: Canton Bourget, commission scolaire.VENTES PAR SHÉRIFS: Gaspè: Dimock vs Després.Hull: Wear Ever Brush Co.Ltd vs Bilodeau et al.Kamourask a: D'Auteuil vs Malenfant.Quebec: Fortin vs Larouchc.Le Comptoir de Crédit ltée vs Auger.Saint-François: Bachand vs Frechette.Terrebonne: Lecours vs Charbonneau.32623-o Bar Examinations: 1383 Laurentides: study of law.1383 Letters Patent: 1383 Rex Film Inc.1383 Supplementary Letters Patent: 1384 Afco Ltd.1384 1384 Anthonian Mining Corporation Ltd.1384 1384 Brandon Furniture Inc.1384 1384 Quemaque Explorers Ltd.1384 1385 Ruby Foo's Incorporated.1385 Department of Finance: Insurances: The Insurance Corporation of Ireland 1385 Limited.1685 Head Offices:' 1385 Gatineau Power Company.1385 Société Internationale de Recherches Economique Inc.\u2014 International 1386 Economic Research Corporation Inc.1386 Tenders: 1385 Mistassini, School Comm.village.1386 Sale Bankruptcy Act: 1387 Pelletier, Philippe.1387 Sale for Taxes: 1388 Township Bourget, School Commission 1388 SHERIFFS' SALES: Gaspé: 1389 Dimock ys Després.1389 Hull: Wear Ever Brush Co.Ltd vs Bilodeau 1389 ctal.1389 Kamouraska: 1389 D'Auteuil vs Malenfant.1389 Quebec: 1390 Fortin vs Larouche.1390 1390 Le Comptoir de Crédit ltée vs Auger.1390 Saint Francis: 1391 Bachand vs Frechette.1391 Terrebonne: t ' 1391 Lecours vs Charbonneau.1391 32023-o Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer. «A "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.