Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 7 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1952-06-07, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 84, N° 23 1443 Vol.84, No.23 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 7 juin 1952 AVIS AUX INTÉRESSSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéresses, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6* Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7* La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 7th, 1952 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by-accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorité comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, claase.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.0270 1444 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 23 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9* Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.31753 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration 8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namejy 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.\u201e Subscriptions: S7.per, year.\u2022N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u20141-52 Lettres patentes A.Billet Ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre avril 1952, constituant en corporation: Félix-Aurèle Montpellier dit Beaulieu, Léo Beaulieu, contracteurs, Vincent Beaulieu, comptable, tous trois de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer généralement les opérations d'une compagnie de construction sous le nom de \"A.Billet Ltée\", avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pont-Viau, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du procureur général, le vingt-quatre avril 1952.L'Assistant procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.Letters Patent A.Billet Ltéc \u2022 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1952, incorporating: Félix-Aurèle Montpellier dit Beaulieu, Léo Beaulieu, contractors, Vincent Beaulieu, accountant, all three of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally, the business of a construction company, under the name of \"A.Billet Ltée\", with a capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the corporation will beat \"Pont Viau\", judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1952.' L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1445 Ace Holdings Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour d'avril 1952, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry Lyon Arono-vitch, avocats, Freda Pomerance, secrétaire, fille «.majeure, de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Ace Holdings Corporation\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et en 900 actions privilégiées de $100 chacune et le montant avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $15,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour d'avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSILETS.Alpa Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième'jour d'avril 1952, constituant en corporation: Dolek Swicarcik, Abraham Munk, manufacturiers, de la cité d'Outremont, Chil Haber-man, manufacturier, de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, importer et faire le commerce de marchandises sèches, vêtements et articles vestimentaires de toute sorte et description, sous le nom de \"Alpa Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions ordinaires de $50 chacune et 500 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour d'avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSILETS.Acc Holdings Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1952, incorporating: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, Advocates, Freda Pomerance, Secretary, fille majeure, Spinster, of the City of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment Company, under the name of \"Ace Holdings Corporation\".The capital stock of the company is divided into 1,000 common shares having no nominal or par value and into 900 preferred shares of $100 each and the amount with which the company will commence its operations will be $15,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April 1952.L.DÉSILETS, 32708-o Deputy Attorney General.Alpa Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth.day of April 1952, incorporating: Dolek Swicarcik, Abraham Munk, Manufacturers, of the City of Outremont, Chil Haberman, Manufacturer, of the City of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy, import and deal in dry goods, clothing and garments of every kind and description, under the name of \"Alpa Mfg.Co.Ltd.\", with a capital stock of 840,000 divided into 300 common shares of $50 each and 500 preferred shares of $50 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of April 1952.L.DÉSILETS, 32708-o Deputy Attorney General.Easy Off Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq avril 1952, constituant en corporation: Norman Genser, Syndey Phillips, avocats, Rose-Marje Gourgoing, secrétaire, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce, manufacturer et faire le négoce de mélanges à nettoyer, sous le nom de \"Easy Off Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la ville d'Rjerville, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur génréla, le cinq avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSILETS.Easy Off Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April 1952, incorporating: Norman Genser, Sydney Phillips, Advocates, Rose-Marie Bourgoing, Secretary, all of the City of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business, manufacture and deal in cleaning compounds, under the name of \"Easy Off Mfg.Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 3,900 preferred shares having a par value of $10 each and 1,000 common shares having a par value of $1 each.The head office of the Company will be in the Town of Boerville, Judicial District of Rjerville.Dated at the office of the Attorney General.t this fifth day of April, 1952.L.DÉSILETS, 32708-o Deputy Attorney General. 1446 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 81, N° 23 Excelsior Pad Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deuxième jour d'avril 1952, constituant en corporation: Murray Lapin, avocat, de la ville de Hampstead, Marcus Meyer Sperber, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de YVcstmount, Alex Raider, étudiant en droit, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de vêtements, marchandises sèches, tissus textiles, sous le nom de \"Excelsior Pad Company Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et*200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour d'avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSILETS.Excelsior Pad Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April 1952, incorporating Murray Lapin, Advocate, of the Town of Hampstead, Marcus Meyer Sperbcr, Advocate and Queen's Counsel, of West-mount, Alex Raider, Student-at-law, of the City of Montreal, all of Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and.dealers in clothing, dry goods, textile fabrics, under the name of \"Excelsior Pad Company Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 preferred shares of the par value of $100 each and 200 common shares of the par value of S100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of April 1952.L.DÉSILETS, 32708-o Deputy Attorney General.Fournel & Charron Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept avril 1952, constituant en corporation: Lucien Roux, avocat, conseil de la Reine, Lorraine Côté, Hélène St-Denis, secrétaires, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles, nouveautés, marchandises, appareils électriques, articles de fantaisie et de tous articles requis par les clients d'un magasin à rayons, sous le nom de \"Fournel & Charron Ltée\", avec un capital de $40,000 divise en 400 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la(compagnie sera il Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Fournel & Charron Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1952, incorporating: Lucien Roux, advocate, Queen's Counsel, Lorraine Côté, Hélène St-Denis, secretaries, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in furniture, novelties, merchandise, electric appliances, fancy goods and all articles required by clients of departmental stores, under the name of \"Fournel & Charron Ltée\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Laval Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq avril 1952, constituant en corporation: Jean-Paul Dansereau, Jean-Paul Grégoire, avocats, Jean-Marc Goulet, courtier en assurances, tous trois de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme manufacturiers et fabricants de moteurs, de pièces et accessoires de tous genres, sous le nom de \"Laval Industries Ltd.\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.Laval Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies : Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April, 1952, incorporating: Jean-Paul Dansereau, Jean-Paul- Grégoire, advocates, Jean-Marc Goulet, insurance broker, all three of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and makers of motors, parts and accessories of every kind, under the name of \"Laval Industries Ltd.\" with a capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of April, 1952.L.DÉSDLETS, 32708 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.81, No.28 1447 Le Club de Ski Mont Givré Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit avril 1952, constituant en corporation sans capital-actions: André Gibeault, gérant de la Banque de Montréal, John Carré, radio technicien, Paul-Emile Côté, agent d'assurance, tous d'Amqui, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Promouvoir les sports d'hiver, plus spécialement le ski, sous le nom de \"Le Club de Ski Mont Givré Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Amqui, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du procureur général, le huit avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Le Comité* protecteur du Groupe Scout de Lorcttevillc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre avril 1952, constituant en corporation aans capital-actions: Charles-Edouard Renaud, employé civil, Jean-Paul Bertrand, maître de poste, Louis-J.Bédard, mécanicien, Albert Vézina, maître-barbier, Yvon Grondin, instituteur, tous de Loretteville, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Organiser et développer un groupw scout.sous le nom de \"Le Comité protecteur du Groupe Scout de Loretteville Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Loretteville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril, 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DESILETS.Le Club de Ski Mont Givré Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of April, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: André Gibeaidt, manager of the Bank of Montreal, John Carré, radio technician, Paul-Émile Côté, insurance agent, all of Amqui, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To promote winter sports, more especially skiing, under the name of \"Le Club de Ski Mont Givré Inc.\".The amount to which is limited the immovable property which the company may hold, is $20,000.The head office of the corporation will be at Amqui, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of April, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Le Comité protecteur du Groupe Scout de Loretteville Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Charles Edouard Renaud, civil servant, Jean Paul Bertrand, postmaster, Louis J.Bédard, mechanic, Albert Vézina, master barber, Yvon Grondin, teacher, all of Loretteville, judicial district of Quebec, for the following purposes: To organize and develop a scout company, under the name of \"Le Comité protecteur du Groupe Scout de Loretteville Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Loretteville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1952.L.DÉSDLETS, 32708 Deputy Attorney General.Les Placements Trudeau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre avril 1952, constituant en corporation: Roger Trudeau, exécutif, Reina Lepage, secrétaire, fille majeure, Blanka Gyulai, comptable, fille majeure tous de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agent d'immeubles et compagnie de placements, sous le nom de \"Les Placements Trudeau Ltée\", avec un capital de $100,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune, et 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.Les Placements Trudeau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1952, incorporating: Roger Trudeau, executive, Reina Lepage, Secretary, spinster, Blanka Gyulai, accountant,spinster, all of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as real estate agent and as an investment company, under the name of \"Les Placements Trudeau Ltée\", with a capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $100 each, and 900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1952.L.DÉSDLETS, 32708-o Deputy Attorney General. 1448 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 28 New Hollywood Furs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour d'avril 1952, constituant en corporation: Human Black, fourreur, Harry Abra-movitch, comptable, Philip S.Garonce, avocat, tous de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les object suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de fourrures, sous le nom de \"New Hollywood Furs Inc.\", avec un.capital de 840,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 282 Ouest, rue Ontario, en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour d'avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSILETS.New Hollywood Furs Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1952, incorporating: Human Black, Furrier, Harry Abramovitch, Accountant, Philip S.Garonce, Advocate, all of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: Manufacture and deal in all kinds of furs, under the name of \"New Hollywood Furs Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of SI00 each.The head office of the Company will be at 282 Ontario St.West, in the City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1952.L.DÉSILETS.32708-o Deputy Attorney General.Regent Tobacco & Confectionery Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour d'avril 1952, constituant en corporation: George Zgeb, Joseph Zgeb, marchands, Gloria Patricia Zgeb, secrétaire, fille majeure, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de confiseries, tabacs, épiceries, cigares, cigarettes, sous le nom de \"Regent Tobacco & Confectionerv Company Limited\", avec un capital de $60*000 divisé en 600 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté au bureau du Procureur général, ce cinquième jour d'avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSDLETS.Regent Tobacco & Confectionery Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Prov-incd of Quebec, bearing date the fifth day of April 1952, incorporating: George Zgeb, Joseph Zgeb, Merchants, Gloria Patricia Zgeb, Secretary, Spinster, of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: Manufacture and deal in all sorts of confectioneries, tobacco, groceries, cigars, cigarettes, under the name of \"Regent Tobacco & Confectionery Company Limited\", with a capital stock of $60,000 divided into 600 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifth day of April 1952.L.DÉSDLETS, 32708-o Deputy Attorney General.St-Ours Drive Yourself Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept avril 1952, constituant en corporation: Roger Archambault, camionneur, Thérèse Péro-deau Archambault, ménagère, épouse contrac-tuellement séparée de biens dudit Roger Archambault, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, André Archambault, commerçant, tous de la paroisse de St-Ours, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Exercer le négoce de louageurs et locateurs d'automobiles et véhicules de toute autre espèce, sous le nom de \"St-Ours Drive Yourself Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Ours, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du procureur général, le sept avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.St-Ours Drive Yourself Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1952, incorporating : Roger Archambault, truckman, Thérèse Pérodeau Archambault, housewife, wife separate as to property by marriage contract of said Roger Archambault, and duly authorized by the latter for the purposes hereof, André Archambault, merchant, all of the parish of St-Ours, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To carry on the business of lessors and renters of automobiles and vehicles of all kinds, under the name of \"St-Ours Drive Yourself Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Ours, judicial district of Richelieu.1 Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1952.L.DÉSDLETS, 32708 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol 8/t, No.28 1449 Service des Loisirs de St-Louis-de-Gonzague Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept avril 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Daunais, commis de bureau, J.-Édouard Déry, chauffeur d'automobiles, A.Henri L'Abbé, gérant de trafic, André Robi-taille, inspecteur d'assurance, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Développer les loisirs dans la Paroisse de St-Louis de Gonzague, à Montréal, sous le nom de \"Service des Loisirs de St-Louis-de-Gonzague\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 825,000.Le siège social de la corporation sera en la paroisse de St-Louis-de-Gonzague, dans les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du procureur général, le sept avril 1952.L'Assistant procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Transport André Grégoire Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept avril 1952, constituant en corporation: André Grégoire, contracteur, Percy Flynn, avocat, tous deux de Québec, Joseph-Arthur Cadorette, contracteur, de Sillery, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de transport sous le nom de \"Transport André Grégoire Limitée\", avec un capital de S18,000 divisé en 360 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.United Customs Brokers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, H a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre avril 1952, constituant en corporation: Marcel Gaboury, Maurice Herman Fortier, avocats, tous deux de la cité d'Outremont, Mariette Des Rosiers, sténographe, fille majeure, de Ville LaSalle, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires de courtiers de douanes et faire le commerce de produits alimentaires, drogues, produits chimiques, charbon et installations industrielles, sous le nom de \"United Customs Brokers Limited\", avec un capital de $20,000 divisé en 20,000 actions d'une valeur deu pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lacolle, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSDLETS.Service des Loisirs de.St-Louis-de-Gonzague Notice is hereby given that under Part ni of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard Daunais, office clerk, J.Edouard Déry, automobile driver, A.Henri L'Abbé, graffic manager, André Robi-taille, insurance inspector, all of the city of Montreal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To develop recreational facilities in the Parish of St-Louis-de-Gonzague, at Montreal, under the name of \"Service des Loisirs de St-Louis-de-Gonzague\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.- .The head office of the corporation will be in the Parish of St-Louis-de-Gonzague, in the city and district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of April, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Transport André Grégoire Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1952, incorporating: André Grégoire, contractor, Percy Flynn, advocate, both of Quebec, Joseph Arthur Cadorette, contractor, of Sillery, judicial district of Quebec, for the following purposes: To act as a transport company, under the name of \"Transport André Grégoire Limitée\", with a capital stock of $18;000 divided into 360 shares of $50 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of April, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.United Customs Brokers Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1952, incorporating: Marcel Gaboury, Maurice Herman Fortier, Advocates, both of the City of Outremont, Mariette Des Rosiers, Stenographer, Spinster, of Ville LaSalle, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on trade of customs brokers and dealing in food products, drugs, chemicals, coal, industrial equipment, under the name of \"United Customs Brokers, Limited\", with a capital stock of $20,000 divided into 20,000 shares of the par value of $t each.The head office of the Company will be at Lacolle, Judicial District of R>erville.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1952.L.DÉSDLETS, 32807-o Deputy Attorney General. 1450 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 28 West-End Farm Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq avril 1952, constituant en corporation: Laurent Drouin, Jean-Marc Boycr, avocats, Françoise Bellay, Gaétane Richer, secrétaires, tous de la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de distributeurs de pétrole et des produits et sous-produits de toute sorte du pétrole et du gaz naturel, sous le nom de \"West-End Farm Service Ltd\"., avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSDLETS.You Ne Da Bread & Union Bread Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour d'avril 1952, constituant en corporation: Dimchc Gurich, George Russeff, boulangers, de Bourlamaque, Pete Filipovich, Nasto Filipovich, Christo Filipovich, Lazo Filipovich, boulangers, de Val d'Or, distirct judiciaire d'Abi-tibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de pâtissiers et boulangers, sous le nom de \"You Ne Da Bread & Union Bread Company Limited\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège-social de la compagnie sera à Bourlamaque, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, ce qua-.trième jour d'avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSDLETS.West-End Farm Service Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April 1952, incorporating: Laurent Drouin, Jean-Marc Boyer, Advocates, Françoise Bellay, Gaétane Richer, Secretaries, all of the City of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of distributors of petroleum and petroleum products and by-products of every kind and natural gas, under the name of \"West-End Farm Service Ltd.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal., Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of April 1952.L.DÉSILETS, 32708-o Deputy Attorney General.You Ne Da Bread & Union Bread Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April 1952, incorporating: Dimche Gurich, George Russeff, Bakers, of Bourlamaque, Pete Filipovich, Nasto Filipovich, Christo Filipovich, Lazo Filipovich, Bakers, of Val d'Or, Judicial District of Abitibi, for the following purposes: To carry on business generally as pastry-cooks and bakers, under the name of \"You Ne Da Bread & Union Bread Company Limited\", with a capital stock of $100,000 divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Bourlamaque, Judicial District of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April 1952.L.DÉSDLETS, 32708-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Alpine Resorts Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du troisième jour de mai 1952 à la compagnie \"Alpine Resorts Limited\", ratifiant son règlement spécial \"B\", augmentant son capital-actions par la création de 8,000 actions privilégiées nouvelle de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions énoncés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, ce 3e jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32708 L.DÉSDLETS.École Supérieure de Commerce de Quebec, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Supplementary Letters Patent Alpine Resorts Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the third day of May, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the Company \"Alpine Resorts Limited\", ratifying its special by-law \"B\" increasing its capital-stock by the creation of 8,000 new preferred shares of $100.each, subject to the rights and restrictions set forth in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General this 3rd day of May, 1952.L.DÉSDLETS, 32708-o Deputy Attorney General.École Supérieure de Commerce de Quebec, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary let- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol 84, No.23 1451 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 22 avril 1952, à la société \"Ecole Supérieure de Commerce de Québec, Inc.\" étendant les pouvoirs de la corporation en augmentant de $500,000 à $3,000,000.le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation.Daté du burenu du Procureur général le 22 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.ters patent bearing date the twenty-second day of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Prlvince of Quebec, to the corporation \"Ecole Supérieure de Commerce de Québec, Inc.\", extending the powers of the corporation, by increasing from $500,000 to $3,000, 000, the amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire or hold.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of April, 1952.L.DÉSILETS.32708 Deputy Attorney General.La Cie Ktchemin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 avril 1952, à la compagnie \"La Cie Etchemin Ltée\", étendant ses pouvoirs de la manière énoncée dans la résolution.Daté du bureau du Procureur général le 30 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.La Cie Etchemin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary, letters patent, bearing date the thirthieth day of April, 1952, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"La Cie Etchemin Ltée\", extending its powers in the manner set forth in the resolution.Dated at the office of the Attorney General, this thirthieth day of April, 1952.L.DÉSDLETS, 32708 Deputy Attorney General.Le Comité des Chemins d'Hiver de St-Joseph de Kamouraska Inc.Avis est donné qu'en.vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de la dite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 avril 1952, à la compagnie \"Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de St-Joseph et de St-Athanase de Kamouraska, Inc.\", a) changeant son nom en celui de \"Le Comité des Chemins d'Hiver de St-Joseph de Kamouraska Inc.\"; b) changeant les pouvoirs de la.corporation en la manière énoncée dans la résolution adoptée le 3 février 1952; c) changeant son bureau principal de St-Athanase à St-Joseph de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le 23 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSDLETS.Technical Accessories Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 9 mai 1952, changeant le nom de la compagnie \"Mechanical Industries Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 décembre 1951, en celui de \"Technical Accessories Limited\".L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DESDLETS.Le Comité des Chemins d'Hiver de St-Joseph de Kamouraska Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de St-Joseph et de St-Athanase de Kamouraska, Inc.\", a) changing its name into that of \"Le Comité des Chemins d'Hiver de St-Joseph de Kamouraska Inc.\"; 6) changing the powers of the corporation in the manner set forth in the resolution adopted on the 3rd of February, 1952; c) changing its head office from St-Athanase to St-Joseph de Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, April 23, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Technical Accessories Limited Notice is herebu given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the ninth day of May, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Mechanical Industries Ltd.\", incorporated by letters patent dated December 28, 1951, to that of \"Technical Accessories Limited\" Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1952.L.DÉSDLETS, 32708 Deputy Attorney General.William Barbara Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la William Barbara Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of April, 1452 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 23 province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 avril 1952, à la compagnie \"William Barbara Corporation\", ratifiant 1er: son règlement ÎST° 12, réduisant son capital-actions de 820,000 à 84,000 par l'annulation de 1G00 actions ordinaires de 810 chacune; 2°: le règlement N° 13 portant son capital-actions de 84,000 à $200.000 par la création de 1000 actions ordinaires additionnelles de S10 chacune et de 1800 actions privilégiées nouvelles de 8100 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général le 19 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Wilmont Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la.province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941.chapitre 270, des lettres patentes supplémentaires, en date du 28 avril 1952, à la compagnie \"Wilmont Realties Limited\", 1.convertissant les 10,000 actions communes sans valeur au pair en 10,000 actions communes de 81; 2.refondant les 10,000 actions communes de $1 en 1,000 actions communes de $10; 3.convertissant les 1,000 actions communes de $10 en 1,000 actions communes sans valeur au pair; 4.fixant à $15,000 le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations.Daté du bureau du Procureur général le 28 avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DESILETS.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 649 Québec le 28 mai 1952.Présent: Le Lieutenant-gouverneur-en-Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif aux employés de laiterie dans les cités de Québec et de Lévis et un rayon de dix (10) milles de leurs limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de laiterie dans les cités de Québec et de Lévis et un rayon de dix (10) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret numéro 481 du 5 mai 1949, amendé par les arrêtés numéros 582-A du 24 mai 1950 et 541-F du 30 mai 1951, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender ledit décret; Attendu que ladite requête à été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 19 avril 1952; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"William Barbara Corporation\", ratifying: 1.its by-law No.12, reducing its capital stock from $20,000 to $4.000 by the cancellation of 1600 common shares of $10 each; 2.By-law No.13, increasing its capital stock from 84,000 to $200, 000 by the creation of 1600 additional common shares of $10 each and 1800 new preferred shares of $100 each, subject to the rights and restrictions enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, April 19, 1952.L.DÉSILETS, 32708 \u2022 Deputy Attorney General.Wilmont Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of April, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Wilmont Realties Limited\", 1.converting the 10,000 common shares having no par value into 10,000 common shares of $1 each; 2.converting the 10,000 common shares of $1 each into 1,000 common shares of $10; 3.converting the 1.000 common shares of $10 into 1,000 common shares having no par value; 4.fixing at 815,000 the amount with which the company will commence its operations.Dated at the office of the Attorney General, April 28, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 649 Québec, May 28, 1952.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the dairy employees of the cities of Quebec and Levis, and a radiu i of ten (10) miles from their limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the dairy employees of the cities of Quebec and Levis, and a radius of ten (10) miles from their limits, rendered obligatory by the decree number 481 of May 5, 1949, as amended by Orders 582-A of May 24, 1950 and 541-F of May 30, 1951, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree; Whereas the said request was published in the Quebec Official Gazette of April 19, 1952; Whereas no objection was made against the approval of the proposed amendments; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol 84, No.28 1453 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 481, soit modifié comme suit: 1° Les sous-paragraphes 2, 3 et 4 du paragraphe \"g\" de l'article I sont remplacés par les suivants: \"2.Essayeur: désigne toute personne détentrice d'un diplôme de l'École de Laiterie de la Province de Québec qui est préposée à l'échantillonnage du lait et de la crème et à leur vérification quant au pourcentage pour l'épreuve au Babcock.\" \"3.Préposé à la fabrication: désigne toute personne en charge de la fabrication d'un produit laitier ou de ses dérivés, toute personne en charge de la réception de produits laitiers, de la pasteurisation et de l'homogénéisation, toute personne en charge de la fabrication de la crème glacée, travaillant spécifiquement dans ledit département dans une fabrique.\" \"4.Hommes de service: Catégorie \"/l\".'désigne toute personne en charge d'écurie, ou tout mécanicien de machine fixe, chauffeur de bouilloires, charron, peintre, sellier, menuisier, forgeron et gardien de nuit.Catégorie \"B\": désigne toute personne employée au lavage des bidons et bouteilles ainsi que toute personne emplloyée à l'embouteillage.Catégorie \"C\": désigne toute personne occupant une fonction non spécifiquement déterminés dans le décret.Catégorie \"D\": désigne toute personne employée saisonnièrement à l'empaquetage de la crème glacée ainsi qu'au moulage et coupage du beurre (du 15 avril au 15 octobre).\" 2° L'article IV est remplacé par le suivant: \"IV.Salaires minima: Tout salarié, quel que soit le mode de rémunération, ne doit pas recevoir un salaire inférieur à celui mentionné ci-après: Par semaine Contremaître.$55.00 Essayeur.44 00 Préposé à la fabrication.44.00 Expéditeur.45.00 Hommes de service: Catégorie \"A\".42.00 Catégorie \"B\".39.00 Catégorie \"C\".38.00 Catégorie \"D\" Hommes.* 25.00 Femmes.22.00 Vendeur sur la livraison du lait, travaillant régulièrement, que la durée hebdomadaire de son travail soit de 60 heures ou moins, $38.00 pour les premiers 2000 points plus $0.02 par point ad-ditionnef pour toute vente de lait au détail et $0.013^ par point additionnel pour toute vente de lait en gros.Pour l'évaluation des points, 1 pinte de lait est considérée comme 1 point, 1 chopine comme point, 1 demiard comme J-4 de point.La commission sur le beurre doit être de $0.02 la livre sur toute vente faite au prix du détail et % cent la livre sur toute vente au prix de gros.La commission sur la crème doit être de $0.02% sur chaque chopine de crème vendue au prix de détail et de $0.01 lA la chopine sur la crème vendue au gros.Tout vendeur dont le salaire et la commission sont inférieurs à trente dollars ($30.00) par semaine doit recevoir un salaire garanti pour ce montant.Par semaine Vendeur de crème glacée.$40.00 Livreur.40.00 Aide.23.80 It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 481, be amended as follows: 1.Paragraphs 2, 3 and 4 of subsection \"g\" of section I are replaced by the following: \"2.Tester: means any person holding a diploma of the Provincial Dairy School, whose work consists in sampling milk and cream and testing them for the purpose of determining the percentage of fat by means of the Badcock method.\"3.Production superviser: means any person in charge of the fabrication of a milk product or its by-products, any person in charge of the reception of milk products, of the pasteurization and homogenization, and any person in charge of ice-cream making, working specifically in such a department.\" \"4.Service man: Category \"A\": means any person in charge of stables or any stationary engine man, boiler fireman, wheelwirght, painter, harnass-maker, joiner, blacksmith and night watchman.Category \"B\": means any person whose work consists in washing milk-churns and bottles, including all persons working in the bottling department.Category \"C\": means any person whose work or occupation is not specifically determined in the decree.Category \"D\": means any person whose (seasonal) work consists in packing ice cream and moulding as well as cutting butter (from April 15 to October 15).\" 2.Section IV is replaced by the following: \"IV.Minimum wages: No employee, irrespective of the basis of remuneration, shall receive less than the following rates of wages: Per week Foreman.$55.00 Tester.44.00 Production superviser.44.00 Shipper.45.00 Service man: Category \"A\".42.00 Category \"B\".39.60 Category \"C\".38.00 Category \"D\": Male.25.00 Female.22.00 Milk delivery men, working regularly, with a weekly duration of work of 60 hours or less, $38.00 for the first 2,000 points plus $0.02 per additional point for all milk retail sales, and $0.013^ per additional point for all milk wholesales.For the computing of points, one quart of milk shall be considered as 1 point, one pint as ]/2 point, one half-pint as % point.The commission on butter shall be $0.02 per pound, for any sale at retail price, and x/i cent per pound for any sale at wholesale price.The commission on cream shall be $0.02^ per pint of cream sold at retail price, and $0.01 H per pint sold at wholesale price.Any salesman whose wages and commission do not attain thrity dollars per week ($30.00) shall nevertheless receive that amount.Per week Ice cream salesman.$40.00 Delivery man.40.00 Helper.23.80 1454 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 23 L'heure Employé occasionnel.S 0.85 Il ne doit être fait aucune diminution sur le salaire d'un salarié pour les jours de fête religieuse d'obligation, les jours fériés non ouvrables et les jours de congé.Quand, dans une semaine donnée, le nombre d'heures de travail requis d'un salarié, autre que l'employé occasionnel, est inférieur à la semaine normale, il ne doit être fait aucune déduction du salaire prévu au présent article, à moins que la diminution des heures ne soit occasionnée par des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur.\" 3° L'article VIII est remplacé par le suivant: \"VIII.Gîte et couvert: Tout employeur qui fournit le gîte et le couvert ou l'un des deux à son salarié sans aucune obligation cependant de la part de ce dernier de les accepter, peut déduire du salaire de ce salarié trois dollars (83.00) par semaine par pièce pour le gîte, et 80.60 par repas.\" 4° L'article XV est remplacé par le suivant: \"XV.L'employeur doit payer au salarié les repas pris par celui-ci lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, il se trouve éloigné de quinze (15) milles ou plus de la fabrique et ce, à un taux n'excédant pas un dollar et vingt-cinq sous (SI.25) du repas.\" 5° L'article XVII est remplacé par le suivant: \"XVII.Lorsqu'un employeur décide de changer la tournée faite par un vendeur ayant au moins un mois de service, il doit lui payer SO.15 par pinte de lait dont sa livraison est réduite et, de plus, pendant les deux mois qui suivent il doit payer à ce vendeur un salaire non inférieur à celui qu'il recevait au moment du changement de sa tournée.\" 6° L'article IV-A intitulé \"Boni de vie chère\" est abrogé.(Document \"A\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 32747-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 649 Québe le 28 mai 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Section \"B\" Concernant une modification au décret relatif aux métiers d'horloger et de bijoutier dans les cités et villes de certains comtés de la province.Attendu que conformément à la procédure prévue à l'article 8 de-la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation d'une modification au déerret numéro 163 du 12 février 1948, amendé par les arrêtés numéros 867-B et 1039-C des 9 juin et 4 août 1948, 108-C et 480-B des 3 février et 5 mai 1949, 183-B et 471-D des 8 février et 26 avril 1950, 425-C du 19 avril 1951 et 1228-C du 31 octobre 1951, relatif aux métiers d'horloger et de bijoutier dans les cités et villes de certains comtés de la province; Per hour Occasional employee.SO.85 No deduction may be made from the wages of an employee because of religious and other holidays or days oil\".When, in the course of a week, the number of hours of work required from an employee, other than an occasional employee, is less than that of the standard work week, there shall be no deduction from the wages established in the present section unless the reduction in working hours be due to circumstances beyond the employer's control.3.Section Mil is replaced by the following: \"VIII.Room and board: Every employer who furnished room and/or board to his employee, the latter not being compelled however to accept same, may deduct from the said employee's wages 83.00 per week per room, for lodging and 80.60 per meal.\" 4.Section XV is replaced by the following \"XV.The employer shall pay for the employees' meals taken on duty at least fifteen (15) miles away from the milk works.The maximum rate for any such meals shall be SI.25.\" 5.Section XVTI is replaced by the following: \"XVII.When the employer decides to change the run of a seller having put in at least one month's service, he shall pay such seller 80.15 per quart of milk by which the latter's run is reduced and, for the following two months, a salary not inferior to that which was paid to him at time of the reduction of the run.\" 6.Section IV-A headed \"Cost of living bonus\" is deleted.(Document \"A\" annexed to the order) A.MORISSET, 32747-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 649 Quebec, May 28, 1952.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"7i\" Concerning an amendment of the decree relating to the clockmaking and jewellery trades in the cities and towns of some counties of this province.Whereas, pursuant to the procedure established under section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of an amendment to the decree number 163 of February 12, 1948, as amended by Orders 867-B and 1039-C of June 9 and August 4, 1948, 108-C and 480-B of February 3 and May 5, 1949, 183-B and 471-D of February 8.and April 26, 1950, 425-C \u2022 of April 19, 1951, and 1228-C of October 31, .1951, relating to the clockmaking and jewellery trades in the cities and towns -of some counties of the province; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol 84, No.28 1455 Ayvendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 19 avril 1952; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 163, cesse de s'appliquer au comté de Hull et que ce comté soit radié de la description de sa juridiction territoriale apparaissant à l'article III.(Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 32717-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 649 Québec, le 2S mai 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Section \"C\" Concernant une modification au décret relatif aux métiers de l'imprimerie dans l'Ile de Montréal et un rayon de cent (100) milles de ses limites.Attendu que conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de proposer l'approbation d'une modification du décret numéro 3088 du 7 août 1946, amendé par les arrêtés numéros 4155 et 4453 des 10 et 31 octobre 1946, 37, 40G-B et 1310-A des 9 janvier, 8 mars et 12 août 1947, 245-E du 26 février 1918, 205-A du 24 février 1949, 319-A du 28 mars 1951 et 271-1 du 20 mars 1952, relatif aux métiers de l'imprimerie dans l'Ile de Montréal et un rayon de cent (100) milles de ses limites; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 12 avril 1952; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 3088, soit modifié comme suit: Au paragraphe \"6\" de l'article II (Juridiction territoriale) les mots \"au 15 juin 1946\" apparaissant dans la description des zones II et III sont remplacés par les mots \"au 15 juin 1950\".(Document \"C\" annexé à l'arrêté).A.MORISSET, 32747-o Greffier du Conseil Exécutif.v - ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro- 649 Québec, le 28 mai 1952.Présent: Le Lieutnant-Gouverneur en Conseil.Section \"F\" Concernant la prolongation du droit de prélè- Wiiereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 19, 1952; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendment; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 163, shall cease to apply to the county of Hull and that this county be deleted from its territorial jurisdiction as described in section III.A.MORISSET, 32747-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 649 Quebec, May 28, 1952.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Part \"C\" Concerning an amendment of the decree relating to the printing trades in the Island of Montreal and a radius of one hundred (100) miles from its limits.Whereas, pursuant to the procedure established under section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the approval of an amendment to the decree number 3088 of August 7,1946, as amende by Orders 4155 and 4453 of October 10 and 31, 1946,37,406-B arftl 1310-A of January 9, March 8 and August 12, 1947, 245-E of February 26, 1948, 205-A of February 24, 1949, 319-A of March 28, 1951 and 271-1 of March 20, 1952.relating to the printing trades in the Island of Montreal and a radius of one hundred (100) miles from its limits; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 12, 1952; Whereas no objection has been made against the approval of the prop'osed amendment; It is irdained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 3088, be amended as follows: In subsection \"6\" of section U s (territorial jurisdiction), the words \"June 15th, 1946\", as mentioned in the description of zones II and III, are replaced by the words \"June 15th, 1950\".(Document \"C\" annexed to the order).A.MORISSET, 32747-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCDL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 649 Quebec, May 28, 1952.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part **Fn Concerning an extension of the right to levy of 1456 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec ,7 juin 1952, Tome 8A, N° 28 vement du Comité paritaire du commerce de l'alimentation au détail à Québec.Il est on donné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité paritaire du commerce de l'alimentation au détail à Québec autorisé par règlement, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 140-1) du 8 février 1951, soit prolongé jusqu'au 31 juillet 1952, aux mêmes taux et conditions.(Document \"F\" annexé à l'arrêté).A.MORISSET, 32747-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEtt EXÉCUTIF Numéro 649 Québec, le 28 mai 1952.Présent: Le Lieutenant-Gouvemeur-en-Consei Section \"H\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement de la Commission conjointe des coiffeurs pour dames de Montréal.Il est ordonné, sur proposition de l'honorable Ministre du Travail : Que le droit de prélèvement de la Commission conjointe des coiffeurs pour dames de Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 540-C du 30 mai 1951, soit prolongé pour une période de deux mois, aux mêmes taux et conditions.(Document \"H\" annexé à l'arrêté) A.MtJRISSET, 32747-o Greffier du Conseil Exécutif.the Retail Food Trade Parity Committee of Quebec.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the right to levy of the Retail Food Trade Parity Committee of Quebec, authorized by a by-law approved by Order in Council number 140-D of February 8, 1951, be extended until July 31, 1952, with the same rate and conditions.(Document \"F\" annexed to the order).A.MORISSET, 32747-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 649 « Quebec, May 28, 1952.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"II\" Concerning an extension of the right to levy of the Joint Commission of the ladies Hair-dressing Trade of Montreal.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the right to levy of the Joint Commission of the Ladies Hairdressing Trade of Montreal, authorized by a by-law approved by Order in Council number 540-C of May 30, 1951, be extended for a period of two months with the same rate and conditions.(Document \"H\" annexed to the order) A.MORISSET, 32747-0 Clerk of the Executive Council.¦ \"Li .i 1 1 i I ' r !.Avis divers Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Canbanco Employees Credit Union\", en date du 15 mai 1952, dont le siège social est situé à Montréal, dans le comté d'Hochelaga, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 19 mai 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32710-o JEAN BRUCHÊSI.Les Magasins Farmer Ltée Règlement \"X\" ' Les distribution de l'actif de la compagnie entre les actionnaires est, par les présentes, autorisée au prorata du nombre d'actions détenues par chacun.Vrai sommaire certifié du règlement \"X\" de la compagnie \"Les Magasins Farmer Ltée\".Montréal, P.Q., 23 avril 1952.Le Secrétaire-trésorier, 32711-0 MARGUERITE-COTÊ-FARMER.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Can-banco Employees Credit Union\" under date the 15th day of May, 1952, whereof the head office is at Montreal, county of Hochelaga, and the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, May 19, 1952.JEAN BRUCHÊSI, 32710 Under Secretary of the Province.Les Magasins Farmer Ltée By-law \"X\" The distribution of the assets of the Company amongst the shareholders rataby to the number of shares held by each is hereby authorized.Certified true summary of By-law \"X\" of \"Les Magasins Farmer Ltée\".Montreal, P.Q., April 23rd, 1952.MARGUERITE-COTE-FARMER, 32711-o Secretary-treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1457 AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de L'U.C.C, de St-Edgar\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 21 mai 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à St-Edgar, comté de Bonaventure.Le Sous-secrétaire de la Province, 32712-q JEAN BRUCHÊSI.L.G.Beaubien & Cie, Limité Règlement N° 3 (Augmentant le nombre des directeurs de sept à onze) Extrait des minutes d'une assemblée du bureau de direction de L.G.Beaubien & Cie, Limitée tenue à Montréal le 25 février 1952.\"Il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement N° 3 modifiant le règlement N° 2, lequel modifiait le premier paragraphe de l'article III du règlement N° 1 de 4a compagnie de manière à ce qu'il se lise comme suit: Article III Bureau de direction 1° Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction de onze directeurs choisis parmi les actionnaires de la compagnie; le quorum [des assemblées du bureau de direction consistera en cinq directeurs.\" Montréal, 20 mai 1952.Vraie copie.(Sceau) Le Secrétaire, 32713 GASTON MAGNAN.Avis de Changement de Nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé le 9 mai 1952, le changement de nom du \"Syndicat Catholique National des Employés de Granby Elastic Web, Inc.\", en celui de \"Syndicat National Catholique des Employés de la Granby Elastic & Textile Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, (S.R.Q., 1941, chapitre 162).Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 13 mai 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32714-0 JEAN BRUCHÊSI.The Kinsmen Club of Pointe Claire Règlement cinq (augmentant le nombre des directeurs ,de 10 à 11) Article I.Nombre des directeurs.Le bureau de direction sera composé de onze (11) directeurs, chacun desquels sera un membre actif de la corporation.Le Secrétaire, 32715 D.SPALDING.* NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de L'U.C.C, de St-Edgar\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 21, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at'St-Edgar, county of Bonaventure.JEAN BRUCHÊSI, 32712 Under Secretary of the Province.L.G.Beaubien & Co., Limited By-Law No.3 (Increase in the number of Directors from seven to eleven).Extract of the minutes of a meeting of the Board of Directors of L.G.Beaubien & Co., Limited, held in Montreal, February 25, 1952.\"It is unanimously resolved to adopt By-Law No.3 amending By-Law No.2 which modified the first paragraph of Article III of By-Law No.1 of the Company so that it will read as follows: Article III Board of Directors 1.The affairs of the Company will be administered by a Board of eleven Directors chosen amongst the shareholders of the Company; the quorum of Board meetings will consist of five Directors.\" Montreal, May 20, 1952.True Copy (Seal) GASTON MAGNAN, 32713-0 Secretary.Notice of Change of Name (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable, the Provincial Secretary, under date of May 9, authorized the change of name of \"Syndicat Catholique National des Employés de Granby Elastic Web, Inc.\", to that of \"Syndicat National Catholique des Employés de la Granby Elastic & Textile Inc.\", and such pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act, (R.S.Q., 1941, chapter 162).Dated at the office of the Provincial Secretary, May 13, 1952.JEAN BRUCHÊSI, 32714 Under Secretary of the Province.The Kinsmen Club of Pointe Claire By-Law five (increasing the number of directors from 10 to 11).Article I.Number of Directors.The Board of Directors shall consist of eleven (11) Directors, each of whom shall be an active member of the Corporation.D.SPALDING, 32175-o Secretary. 1458 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 28 Blue Valley Corp'n Règlement XXII (Augmentant le nombre des directeurs de 3 à 5) Le nombre des directeurs de la compagnie sera de cinq et le règlement N° 11 de la compagnie est amendé en conséquence.Le Président, 31730 MARCEL LAJEUNESSE.Blue Valley Corp'n By-law XXII (Increasing the member of Directors from 8 to 6) The number of Directors of the Company shall be five and By-law No.11 of the Company is amended accordingly.MARCEL LAJEUNESSE, 32730-o President.AVIS (Loi des Syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 30 mai 1952, la fin de l'existence corporative du \"Syndicat National des Maisons Pré-fabriquées de Québec Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q., 1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi II Georges VI, chapitre 52, article 5.Doné au bureau du Secrétaire de la Province le 2 juin 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32708-o JEAN BRUCHÊSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, on May 30, 1952, enacted the termination of the.corporate existence of the \"Syndicat National des Maisons Pré-fabriquées de Québec Inc.\", pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act n Georges VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, June 2, 1952.JEAN BRUCHÊSI, 32708 Under Secretary of the Province.Province de Québec \u2014 District de Montréal Paroisse de Saint Laurent Règlement N° 88 Assemblée régulière du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Laurent, comté de Jacques-Cartier, tenue à la salle de l'école St-Louis, lieu ordinaire des séances du Conseil, mercredi le seizième jour du mois d'avril mil neuf cent cinquante deux, à huit heures de l'après-midi, étant l'ajournement de l'assemblée du 7 avril, et à laquelle sont présents Son Honneur le Maire Hector Leduc et Messieurs les conseillers Leopold Gohier, Léo Cardinal, Elphège Jasmin, Sigefroy Noël, Armand Groulx et Emile Noël, le Conseil étant au complet et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire.Attendu que par l'article 81a du code municipal, ajouté au dit code pour la Corporation de la Paroisse de St-Laurent par la Loi 15-16 Georges VI, chapitre 112, le Conseil peut par règlement fixer à trois ans la durée du mandat du maire et des conseillers municipaux; Attendu que le développement immobilier se poursuit d'une façon constante dans cette municipalité; Attendu que pour assurer une meilleure administration du budget municipal et des affaires de la Corporation en général, il est à l'avantage et dans l'intérêt des contribuables de cette municipalité que la durée du mandat du maire et des conseillers élus ou nommés, soit fixés à trois ans à compter de leur élection respective ou de leur nomination respective; Attendu que les élections occasionnent à cette corporation une dépense appréciable, il est en conséquence proposé par Monsieur le Conseiller Elphège Jasmin, conformément à l'avis de motion qu'il a donné en assemblée de ce Conseil tenue le 7 avril, appuyé par Monsieur le Conseiller Leopold Gohier, et adopté à l'unanimité, qu'il soit statué et ordonné par règlement du Conseil municipal de la Paroisse de St-Laurent, Province of Quebec \u2014 District of Montreal Parish of Saint Laurent By-Law No.88 Regular meeting of the Municipal Council of the Parish of Saint-Laurent, county of Jacques-Cartier, held in the St-Louis school hall, the usual meeting place of the Council, on Wednesday, the sixteenth day of the month of April, one thousand nine hundred and fifty-two, at eight o'clock in the evening, being the adjournment of the meeting of the 7th of April, and at which were present His Honour the Mayor Hector Leduc and Messrs the councillors Leopold Gohier, Léo Cardinal, Elphège Jasmin, Sigefroy Noël, Armand Groulx and Emile Noël, the Council being complete and in session with His Honour the Mayor presiding.Whereas Article 81a of the Municipal Code, added to the said Code for the Corporation of the Parish of St-Laurent by the Act 15-16 Georges VI, chapter 112, the council may, by by-law, fix at three years the term of office of the mayor and municipal councillors; Whereas immovable development is being constantly carried on in this municipality; Whereas to assure a better administration of the municipal budged and the affairs of the Corporation in general, it is to the advantage and in the interest of the ratepayers of the said municipality that the duration of the mandate of the mayor and councillors elected or appointed, be fixed at three years as from their respective election or their respective appointment; Whereas elections incur considerable expense to the said corporation, therefore it was moved by Mr.the Councillor Elphège Jasmin, in conformity with the motion made by him at the Council meeting held on April 7, seconded by Mr.the Councillor Leopold Gohier, and unanimously adopted, that it be enacted and ordained by by-law of the Municipal Council of the Parish of St-Lau- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.23 1450 et il est par le présent règlement portant le numéro 88 des règlements de cette corporation statué et ordonné ee qui suit: Article t.La durée du mandat du maire et des conseillers municipaux de cette corporation est par le présent règlement fixée à trois ans à compter de leur élection respective ou de leur nomination respective.Article 2.Les prescriptions du eode municipal concernant la durée du mandat du maire et des conseillers sont en conséquence modifiées nonobstant toute disposition législative inconciliable de façon à appliquer le présent règlement.Article 3.Le présent, règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par la majorité des électeurs municipaux ayant voté au sujet du dit règlement et conformément aux dispositions de la Loi.Le Maire.(Signé) HECTOR LEDUC.Le Secrétaire-trésorier, EMILE BÉLANGER.Vraie copie.Le Secrétaire-trésorier, 32727-0 EMILE BÉLANGER.rent, and it is by the present By-law No.88 of the by-laws of the said Corporation enacted and ordained as follows: Article I.The duration of the mandate of the mayor and municipal councillors of the said Corporation is, by the present by-law, fixed at three years as from their respective election or their respective appointment.Article J.The provisions of the M unicipal ( 'ode concerning the duration of the mandate of the mayor and councillors are consequently amended notwithstanding any inconsistent legislative provision, so as to apply the present by-law.Article 3.The present by-law will come into force after having been approved by the majority of municipal electors who have voted in respect of the said by-law and pursuant to the provisions of the Act.(Signed) HECTOR LEDUC, Mavor.EMILE BÉLANGER, Secretary-Treasurer.True copy.KM ILE BÉLANGER, 32727 Secretary-Treasurer.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de New Richmond\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres,a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 30 mai 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à New Richmond, comté de Bonaven-ture.Le Sous-secrétaire de la Province.32738-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Saint-Godefroi\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 30 mai 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Godefroi.comté de Bonaven-ture.Le Sous-secrétaire de la Province, 32739-0 JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicast professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de L'U.C.C.de St-Omer\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 20 mai 1952.Le siège social du syndicta professionnel précité est situé à New Richmond, comté de Bonaventure! Le Sous-secrétaire de la Province, 32740-o JEAN BRUCHÊSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de New Richmond\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 30, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at New Richmond, county of Bona venture.JEAN BRUCHÊSI, 32738 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Saint-Godefroi\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 30, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Godefroi, countv of Bonaventure.JEAN BRUCHÊSI, 32739 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Omer\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 20, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at New Richmond, Countv of Bonaventure.JEAN BRUCHÊSI, 32740 Under Secretary of the Province. 1460 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Qtiêbcc, 7 juin 1952, Tome S.',, N° 28 Gulf Securities Corporation Limited Règlement \"D\" \"Le bureau de direction sera formé de cinq actionnaires en règle, dont trois formeront quorum\".Je, le soussigné, Jean W.Cook, secrétaire de la compagnie Gulf Securities Corporation Limited\", par les présentes, certifie que le précédent est une vraie copie du règlement \"D\" de ladite compagnie \"Gulf Securities Corporation Limited\", lequel a été décrété à l'unanimité à une assemblée des directeurs de la compagnie tenue le 24e jour de juillet 1050 et ratifié à l'unanimité à une assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite compagnie dûment convoquée dans le but de considérer ledit règlement et tenue sub-séquemmeut le 24e jour de juillet 1950.Montréal, le 7 mai 1952.(Sceau) Le Secrétaire, 32737 JEAN W.COOK.Avis est, par les présentes, donné (pie, sur la recommandation de Y Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 26 mai 1952, le règlement N° 1 de \"The Morgan Arboretum and Woodland Development Association\", conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 2S mai 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32741 JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Maria, comté de Bonaventure\".pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 21 mai 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Bonaventure.comté de Bonaventure.Le Sous-secrétaire de la Province, 32749-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat des Employés de Dennison Mfg., Co.Ltd\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 5 juin 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Drummondville, dans le district d'Arthabaska.Le Sous-secrétaire de la Province, 32762-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat des Maîtres-Artisans Barbiers du District de St-François\", pour l'étude, la défense Gui.f Securities Corporation Limited By-Law \"D\" The Board of Directors shall consist of five shareholders in good standing, of whom tfircc shall form a quorum.I, the undersigned Jean W.Cook, Secretary of Gulf Securities Corporation Limited, hereby certify the foregoing to be a true copy of By-Law \"D\" of the said Gulf Securities Corporation Limited, which was unanimously enacted at a Meeting of Directors of the Company held on the 24tb.day of July, 1950, and unanimously ratified at a Special General Meeting of Shareholders of the said Company duly called for the purpose of considering the said By-Law and held subsequently on the 24th.day of July, 1950.Montreal, May 7th., 1952.(Seal) MEAN W.COOK, 32737-o Secretary.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved on May 20, 1952, By-law No.1 of \"The Morgan Arboretum an Woodland Development Association\", pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at.the office of the Provincial Secretary the 28th day of May, 1952.JEAN BRUCHÊSI, 3274l-o Under-Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de L'U.C.C.de Maria, comté de Bonaventure\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May 21, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at Bonaventure, County of Bonaventure.JEAN BRUCHÉSU, 32749 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat des Employés de Dennison Mfg.Co.Ltd.\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June 5, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at Drummondville, county of Arthabaska.JEAN BRUCHÊSI, 32762 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat des Maîtres-Artisans Barbiers du District de St-François\", for the study, defence QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1461 et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 5 juin 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sherbrooke, dans le district de St-François.Le Sous-secrétaire de la Province, 32763-o JEAN BRUCHÊSI.* and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June 5, 1952.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sherbrooke, district of St.Francis.JEAN BRUCHÊSI, 32763 Under Secretary of the Province.Actions en séparation de biens Actions for separation as to property Province de Québec, District des Trois-R-vières.Cour Supérieure N° 13-098.Dame Laure St-Laurent, demanderesse, vs Louis-Henri Laplante, défendeur.Dame Laure St-Laurent, ménagère, épouse commune en biens de Louis-Henri Laplante, homme d'affaires, autrefois du Cap-de-la-Madeleine, district des Trois-Rivières, et présentement sans domicile connu, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Les Trois-Rivières, le 29 mai, 1952.Les Procureurs de la demanderesse, 32709-o MARCHAND & LACOURSIÈRE.Canada, province de Québec, District de Terrebonne, Cour Supérieure, N° 21590.Dame Florida Patry, ménagère et épouse d'Alphège Lorange, domicilié au numéro 406 rue St-Gcorgcs, St-Jérôme, district de Terrebonne, P.Q., demanderesse, vs Alphège Lorange, domicilié au numéro 406, rue St-Georges, St-Jérôme, district de Terrebonne, P.Q., défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 28 mai 1952.Montréal, le 30 mai, 1952.Le Procureur de la demanderesse, 32728-0 YVON PERRAS.Canada, province de Québec, District de Terrebonne, (Jour Supérieure, N° 21508.Dame L.Aimé Roy, ménagère de St-Eustache, Cté Deux-Montagnes, province de Québec, demanderesse, vs J.Charlemagne Lavallée, des mêmes lieux, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 16 avril 1952.Montréal le 26 mai 1952.Le Procureur de la demandresse.32729-0 YVON PERRAS.Province of Quebec, District of Trois-Rivières, Superior Court, No.13-098.Dame Laure St-Laurent.plaintiff, vs Louis-Henri Laplante, defendant.Dame Laure St-Laurent, housekeeper, wife common as to property of Louis-Henri Laplante, business man, formerly of Cap-de-la-Madelcine, district of Trois-Rivières, and now of unknown domicile, has taken an action against her husband for separation as to property.Les Trois-Rivières, June 29th, 1952.MARCHAND & LACOURSIÈRE, 32709-q Attorneys for plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne, Superior Court.No.21590.Dame Florida Patry, housekeeper, and wife of Alphège Lorange.domiciled at number 406 St-Georges St.St-Jérôme, District of Terrebonne, P.Q., plaintiff, vs Alphège Lorange, domiciled at number 406 St-Gcorges Street, St-Jérôme, District of Terrebonne.P.Q., defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case on May 28th, 1952.Montreal, this May 30.1952.YVON PERRAS, 32728-0 Attorney for plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne, Superior Court, No.21508.Dame L.Aime Roy, housekeeper, of St.Eustache, Deux-Montagnes, Co.province of Quebec, plaintiff, vs J.Charlemagne Lavallée.of the same place, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case on April 16th 1952.Montreal, this 26 day of Mav, 1952.YVON PERRAS, 32729-0 Attorney for plaintiff.Action en séparation de corps Action for Separation as to Bed et de biens and Board Canada, Province de Québec, District de St- Canada, Province of Quebec, District of St-François, Cour Supérieure, N° 10128, Dame Hélè-: Francis, Superior Court, No.10128, Dame Helena na Bergeron, épouse commune en biens de Flo- Bergeron, wife common as to property of Flo-rent Couture, ladite dame domiciliée au N° 214-B, rent Couture, the said wife domiciled at 214-B, Blvd.Alexandre, à Sherbrooke, district de St- Blvd.Alexandre, in the city of Sherbrooke, disFrançois vs ledit Florent Couture, autrefois do- trict of St.Francis vs the said Florent Couture micilié à Sherbrooke, district de St-François et formerly domiciled in the city of Sherbrooke and maintenant domicilié dans un lieu inconnu.now domiciled in an unknown place.La.demanderesse a formé contre son mari une The plaintiff has instituted against her hus- demande en séparation de corps et de biens.band an action in separation as to bed and board.Sherbrooke, ce 27 mai 1952.Sherbrooke.Mav 27th, 1952.L'Avocat de la demanderesse, ' FRANÇOIS POULIN, 32736-0 FRANÇOIS POULIN.32736-o Attorney for the plaintiff. I4G2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.7 juin 1952, Tome 8/\u201e N° 23 Chartes \u2014 Abandon de Ayeh's Cliff Creamery Limited La compagnie .susmentionnée, dont le bureau chef est à Ayer's Cliff, Québec, a demandé la permission d'abandonner sa charte en vertu de l'article 20 de la Loi des Compagnies «le Québec.Daté A Coaticook, Que., ce 1 juin, 1952.Procureurs de la requérante, 32716-0 SHURTLEFF & BOUCHARD.(îROvEiiiLL Golf & Country Club Inc.Avis est donné, conformément à la loi des compagnies de Québec, que \"Grovehill Golf & Country Club Incorporated\" demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 2G mai 1952.Grovehill Golf and Country Club, Inc.Par le secretaire, 32717-o J.L.COTÉ.Avis est donné qu'une demande sera faite au Lieutenant-gouverneur en Conseil par la compagnie \"Melbrook Garment Incorporated*', le priant de lui accorder la permission dtabandonner sa charte, à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Montréal, le 28 mai 1952.Le Procureur de \"Melbrook Garment Incorporated\", 32718 MANUEL A.MENDELL, C.R.La Compagnie d'Approvisionnement d'Eau Limitée AVIS En vertu des dispositions de la Loi des Compagnies de Québec, telle qu'amendée, \"La Compagnie d'Aprpovisionnement d'Eau Limitée\" donne avis par les présentes, qu'elle fera application à l'Honorable Procureur Général de Québec pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en ordonne son annulation en date du 1er avril 1952.Cap St-Ignace, le 23 mai 1952.Le Secrétaire, 32742-o MARCEL GUIMONT.Durieux Entreprises Inc.Avis est donné (pic la compagnie \"Durieux Entreprises Inc.\", incorporée en vertu de la , Ix>i des compagnies de Québec et ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'adressera au Procureur Général de la Province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des Compagnies de Québec.Daté à Montréal, le 27 mai 1952.Le Secrétaire, 32750-o YOLANDE TURGEON.Les Produits Laitiers Laurentide Limitée Avis est par la présente donné (pie \"Lès Produits Laitiers Laurentide Limitée,\" une corporation constituée en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, fera une requête au Procu- Charters \u2014 Surrender of Ayer's Cliff Creamery Limited The above named company, with head office at Ayer's Cliff, Quebec, has made application for leave to surrender its charter under section 20 of the Quebec Companies' Act.Dated Coaticook, Quebec, June 1, 1952.SHURTLEFF & BOUCHARD, 32710-o Attorneys for applicant.Grovehill Golf & Country Club Inc.Notice is given, pursuant to the Quebec Companies' Act, that \"Grovehill Golf & Country Club Incorporated\" will apply for leave to surrender its charter.Montreal.May 26, 1952.Grovehill Golf & Country Club Inc.Per J.L.COTÉ, 32717 Secretary.Notice is hereby given that application will be made to the Lieutenant-Governor in Council by \"Melbrook Garment Incorporated\", praying that permission be granted to surrender its charter, from and after the date which the Lieutenant-Governor may be pleased to determine.Montréal, Mav 28th, 1952.MANUEL A.MENDELL, Q.C., Attorney for 32718-0 Melbrook Garment.Incorporated.La Compagnie d'Aprpovisionnement d'Eau Limitée NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act.as amended \"La Compagnie d'Approvisionnement d'Eau Limitée\" hereby gives notice that it will make application to the Honorable the Attorney General of the province of Quebec for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation from the date of April 1st 1952.Cap St-Ignace, May 23rd, 1952 Secretarv.32742-0 MARCEL GUIMONT.* Durieux Entreprises Inc.Notice is hereby given that \"Durieux Entreprises Inc.\" a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its bead office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 27th Mav 1952.YOLANDE TURGEON, 32750-o Secretary.Les Produits Laitiers Laurentide Limitée Notice is hereby given that \"Les Produits Laitiers Laurentide Limitée\", a corporation incorporated under the Quebec Companies' ^.ct, will apply to the Attorney General of the Province of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.HJ\u201e No.23 1463 reur Général de la Province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des Compagnies de Québec.Montréal, ce 4 juin 1952.Le Secrétaire, 32751-o ROBERT LA FLEUR.P.Sanguinet Limitée Avis est donné que la compagnie \"P.Sanguinet Limitée\" a l'intention de s'adresser au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.Daté en la cité de Montréal, ce 30ième jour de mai 1952.Le Secrétaire, 32752 LAURETTE SANGUINET.Avis est donné par les présentes que \"Venus Jewellery Mfg.Ltd.\", demandera la permission d'abandonner sa charte à compter d'une date à être fixée.Venus Jewelleuy Mfo.Ltd.par Le Secrétaire, JOSEF HERZOG.Les Procureurs 4e Venus Jewelleuy Mfg.Ltd., LOUIS & BERGER 32753-o Compagnie autorisée à faire des affaires Avis est donné que la compagnie \"Dan River Mills, Incorporated.\" a été dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature crées en vertu des Lois de la province de Québec, et sujets aux mêmes formalités telles que prescrites par les lois existantes de cette Province.L'Agent principal de la compagnie dans la Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure intentée contre elle, est M.Kenneth Harold Brown, Conseil en Loi de la Reine, de Chambre 1505, 507 Place d'Armes, en ladite cité de Montréal.Le siège social de la compagnie sera à 660 ouest, rue Ste-Catherine, en les cité et district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 4 juin 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32708 JEAN BRUCHÊSI.Compagnies dissoutes Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276.article 26, et sujet, à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Christie Mining Syndicate Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er mai 1936.Quebec for leave to surrender its charter under the Quebec Companies' Act.Montreal, June 4.1952.ROBERT LAFLEUR, 32751 Secretary.P.Sanguinet Limitée Notice is hereby given that \"P.Sanguinet Limitée\" intends to make application to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter pursuant to the provisions of Sections 26 of the Companies' Act.Dated at the City of Montreal, this 30th day of May, 1952.LAURETTE SANQUINET, 32752-o Secretary.Notice is hereby given that \"Venus Jewellery Mfg.Ltd.\", will apply for leave to surrender its Charter at a date to be fixed.Venus Jewellery Mfg.Ltd.Per JOSEF HERZOG, Secretary.LOUIS & BERGER Attorney for Venus Jewellery Mfg.Ltd.32763-0 Company Licensed to do Business Notice is hereby given that the company \"Dan River Mills, Incorporated, has been duly licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred on the said company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and the company shall be subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.Its chief agent in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it.is Kenneth Harold Brown, Queen's Counsel, of Room 1505, 507 Place d'Armes, in the said City of Montreal.The head office in the Province is to be established at 060 St.Catherine Street West, in the City and Judicial District of Montreal.Given al the office of the Provincial Secretary, on June 4, 1952.JEAN BRUCHÊSI, 32708 Under Secretary of the Province.Companies Dissolved Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Christie Mining Syndicate Incorporated\", incorporated by letters patent dated May 1, 1936. 1464 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome S/\u201e N° 23 Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Cowansvillc Realties, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 23 mai 1923.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Darwood Mining Company\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 novembre 1950'.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général.32708-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article'27 de ladite loi, il a plu .au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Goldfinch Mines Limited (No Personal Liability) \", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5 juillet 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la- compagnie \"Laurentian Investment Company\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 avril 1926.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québed, 1941, chapitre 276, article Notice is also given that from and after June 2, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, June 3, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Cowansville Realties,' Limited\" incorporated by letters patent dated May 23, 1923.Notice is also given that from and after June 2, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, June 3, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Darwood Mining Company\" incorporated by letters patent dated November 21.1950.Notice is also given that from and after June, 2, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, June 3, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec.1941.chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Goldfinch Mines Limited (No Personal Liability)\", incorporated by letters patent dated July 5, 1945.Notice is also given that from and after June 2, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, June 3, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Laurentian Investment Company\" incorporated by letters patent dated April 17, 1926.Notice is also given that from and after June 2.1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, June 3,1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.23 1465 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Paul H.Plamondon Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 juillet 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32708-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Victory Investments Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 16 février 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 3270S-o L.DÉSILETS.subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Paul II.Plamondon Inc.\" inerpo-rated by letters patent dated July 11, 1945.Notice is also given that from and after June 2, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attornev General, June 3, 1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Victory Investments Limited\", incorporated by letters patent dated February 16, 1944.\u2022 Notice is also given that from and after June 2, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, June 3.1952.L.DÉSILETS, 32708 Deputy Attorney General.Département de l'Instruction publique N° 635-50.Québec, le 23 mai 1952.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire \"Des Boules\", dans le comté de Matane, en celui de \"Les Boules\".Le Surintendant de l'Instruction publique, 32687-22-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 463-52.Québec, le 26 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Hatley-Ouest, dans le comté de Stanstcad, le territoire ci-dessous décrit, et de l'annexer, pour les contribuables protestants seulement, à la municipalité scolaire d'Ayer's Cliff, dans le même comté.Ce territoire est décrit comme suit, savoir: Commençant au coin sud-ouest de la municipalité scolaire du canton de Hatlcy Ouest, allant vers le nord le long de la ligne entre les rangs VI et VII, jusqu'au lac Massawipi; de là, dans les directions nord et est le long de la limite de la municipalité de Hatley-Ouest, traversant le lac Massawipi jusqu'à la ligne entre les lots 13 et 14; de là, vers l'est le long de cette dernière ligne, jusqu'à la ligne entre les rangs III et IV; de là, vers le sud le long de la ligne entre lesdits rangs jusqu'à la ligne entre les lots 12 et 13; de là, vers l'est le long de cette dernière ligne jusqu'à la ligne entre les rangs III et II; de là, dans une direction sud en suivant cette dite ligne jusqu'à la ligne entre les lots 6 et 7; de là, vers l'oust le long de cette ligne jusqu'à la limite ouest du village de Hatley-Oust aux limites sud du canton de Hatley-Ouest; de là, vers l'ouest le long de cette dite limite sud de Hatley-Ouest, jusqu'à la ligne entre les rangs VI et VII point de départ.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32688-22-2-0 O.J.DESAULNIERS.Department of Education No.635-50.Quebec, May 23, 1952.Application is made to change the name of the school municipality of \"Des Boules\" in the county of Matane, to that of \"Les Boules\".O.J.DESAULNIERS, 32687-22-2 Superintendant of Education.No.463-52.Quebec, May 26, 1952.Application is made to detach from the school municipality of West Hatlcy, in the county of Stanstead, the territory hereinbelow described, and to annex it, for Protestant taxpayers only, to the school municipality of Ayer's Cliff, in the same county.The said territory is described as follows, to wit; Starting at the southwest corner of the school municipality of the township of West Hatley, running northward along the line between ranges VI and VII, up to Lake Massawipi; thence, in northerly and easterly directions along the limit of the .municipality of West Hatley, crossing lake Massawipi as far as the line between lots 13 and 14; thence, eastward along this last line, to the line between ranges III and IV; thence, southward along the line between the said ranges to the line between lots 12 and 13; thence, eastward along the said last line to the line between ranges III and II; thence, in a southerly direction by following the said line to the line between lots 6 and 7 ; thence, westward along the said line to the west limit of the village of West Hatley at the south limits of the township to the township of West Hatley; thence, westward along the said south limit of West Hatley, to the line between ranges VI and VII the starting point.O.J.DESAULNIERS, 32688-22-2 Superintendant of Education. 1466 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 28 N° 247-52.Québec, le 27 mai 1952.Demande est faite d'ériger en municipalité scolaitc distincte sous le nom de Lac Lemoine, dans le comté d'Abitibi-Est, le territoire suivant, du Canton Dubuisson, savoir: Tous les lots des rangs I à V (1 à 5) du Lac Lemoine à la limite est dudit canton qui ne sont pas encore organisés au point de vue scolaire.Le territoire suivant qui sera détaché de la municipalité scolaire de Saint-Bernard, savoir: Les lots du rang YT (6) compris entre le Lac Lemoine à la limite est du même canton.Les lots du rang VII (7) compris entre le Lac Lemoine au lot 56 inclusivement; en plus, la demie sud des lots 57 à 62 inclusivement du même rang.Les lots du rang VIII (8) à compter du Lac Lemoine, de la rivière Piché ou Thompson au lot 56 inclusivement.Dand le rang IX (9), les lots 40 à 43 inclusivement, situés au sud du Lac Montigny.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32690-22-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1142-51.Québec, le 28 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Orford, dans le comté de Sherbrooke, le lot N° 1 du rang V (5); les lots 8 et 9 des rangs X à XIII (10 à 13) inclusivement et les lots 14 à 21 inclusivement des rangs XIV à XVIII (14 à 18) inclusivement du canton d'Orford et de les annexer «à la municipalité scolaire de St-Élie-d'Orford, même comté., Le Surintendant de l'Instruction publique, 32691-22-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 556-52.Québec, le 27 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Orford, dans le comté de Sherbrooke, le lot 27 du rang XII (12) du canton d'Orford, les lots 22 à 27 inclusivement des rangs XIV à XVIII (14 à 18) inclusivement du même canton, et de les annexer à la municipalité scolaire du canton de Magog, comté de Stanstead.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32692-22-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 1139-51.Québec, le 13 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Pont-Viau, dans le comté de Laval, les lots de subdivision du lot originaire 295, portant les numéros 1 à 17 inclusivement des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Martin, et de les annexer à la municipalité scolaire de la Ville de Laval des Rapides, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.32693-22-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 358-52.Québec, le 24 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire du village de St-Pic, dans le comté de Bagot, les lots 877 à 881 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Pie, et de les annexer à la municipalité scolaire de la paroisse de Saint-Pie, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32696-22-2-0 O.J.DESAULNIERS.No.247-52.Quebec, May 27, 1952.Application is made to erect into a separate school municipality under the name of Lac Lemoine, in the county of Abitibi-East, the following territory, of the township of Dubuisson, to wit: All the lots of Ranges I to V (1 to 5) of Lake Lemoine to the Eastern limits of the said township which are not as yet organized as regards schools.The following territory which shall be detached from the school municipality of Saint-Bernard, to wit: The lots of range VI (6) comprised between Lake Lemoine as far as the east limit of the same township.The lots of range VII (7) comprised between Lake Lemoine up to lot 56 inclusively; moreover, the south-half of lots 57 to 62 inclusively of the same range.Lots of range VIII (8) from Lake Lemoine, from the Piché or Thompson River to lot 56 inclusively.In range IX (9) lots 40 to 43 inclusively, situate to the south of Lake Montigny.O.J.DESAULNIERS, 32690-22-2 Superintendent of Education.No.1142-51 Quebec, May 28, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Orford, in the county of Sherbrooke, lot No.1 of Range V (5); the lots 8 and 9 of ranges X to XIII (10 to 13) inclusively and the lots 14 to 21 inclusively of the Ranges XIV to XVIII (14 to 18) inclusively of the township of Orford and to annex them to the school municipality of St-Élie-d'Ordord, same county.O.J.DESAULNIERS, 32691-22-2 Superintendent of Education.No.556-52.Quebec, May 27, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Orford, in the county of Sherbrooke, lot 27 of range XII (12) of the township of Orford, lots 22 to 27 inclusively of ranges XIV to XVIII (14 to 18) inclusively of the same township, and to annex them to the school municipality of the township of Magog, county of Stanstead.O.J.DESAULNIERS, 32692-22-2 Superintendent of Education.No.1139-51 Quebec, May 13, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Pont-Viau, in the county of Laval, the lots of the original subdivision 295, bearing numbers 1 to 17 inclusively of the official plan and in the book of reference for the parish of Saint-Martin, and to annex them to the school municipality of the Town of Laval des Rapides, same county.O.J.DESAULNIERS, 32693-22-2 Superintendent of Education.No.35S-52 Québec, May 24, 1952.Application is made to detach from the school municipality of the village of St-Pie, ill the county of Bagot, lots 877 to 8S1 inclusively on the official cadastre of the parish of Saint-Pie, and to annex them to the school municipality of the parish of Saint-Pie, in the same countv.O.J.DESAULNIERS, 32696-22-2 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1052, Vol.S/f, No.28 1467 N° 536-52.Quebec, le 28 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Rapide-des-Chénes, dans le comté de Gatineau, le territoire ci-dessous décrit et de l'annexer à la municipalité scolaire d'Aylmcr, même comté, savoir: Partant du point d'intersection de la rive Nord-Ouest de la rivière d'Ottawa avec l'axe du chemin de Fraser à la ligne Ouest du lot de subdivision 18-b rang I (1); de là en référence au cadastre officiel du canton de Hull Sud passant par les lignes et démarcations suivantes en continuité les unes des autres, savoir, l'axe du chemin de Fraser en allant vers le nord jusqu'à l'axe du chemin d'Aylmer, le dit axe du chemin d'Aylmcr en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne est du lot de subdivision 18-b rang I, allant vers le sud longeant la ligne est du lot de subdivision 18-b rang I, jusqu'au point d'intersection nord-est de la rivière Ottawa avec l'axe du chemin Foley, de là longeant la rive du lac Deschênes jusqu'au point d'intersection de la rive nord-ouest de la rivière Ottawa avec l'axe du chemin de Fraser.Le Surintendant de l'Instruction publique.32694-22-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 517-52.Québec, le 26 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de St-Nazaire-d'Acton, dans le comté de Bagot, la partie du lot N° 1358, du cadastre officiel de St-Nazaire d'Acton, et de l'annexer à la municipalité scolaire du village de St-Nazaire d'Acton, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32695-22-2-0 A.J.DESAULNIERS.N° 464-52.Québec, le 28 mai 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire protestante de Hatley-Ouest, dans le comté de Stanstead, le territoire suivant, pour l'annexer à la municipalité scolaire du Village de Hatley, dans le même comté, et ce pour les contribuables protestants seulement.Ce territoire est décrit comme suit, savoir: Commençant à un point situé sur la ligne nord de la municipalité du Village de Hatley, «où la ligne entre les rangs II et III rencontre la ligne entre les lots 6 et 7; de là, vers le nord le long de la ligne entre les rangs II et III jusqu'à la ligne entre les lots 12 et 13; de là, vers l'est en suivant cette ligne jusqu'à la limite est de la municipalité de Hatley-Ouest canton ;de là, vers le sud le long de cette dite limite jusqu'à la limite de la municipalité du Village de Hatley; de là, vers l'ouest en suivant cette limite entre les subdivisions 87 au sud et les subdivisions 89 et 90 au nord jusqu'à la ligne entre les rangs I et II; de là, vers le sud le long de cette ligne, en suivant la limite dellatley Village jusqu'à la ligne entre les lots 6 et 7; de là, dans une direction ouest en suivant cette l;gne jusqu'à la ligne entre les rangs II et III, point de départi^ Le Surintendant de l'Instruction publique.32689-22-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 339-51.Québec, le 28 mai 1952.Demande est faite de former en municipalité scolaire distincte, pour les contribuables protestants seulement, sous le nom de \"La munici- No.536-52.Quebec, May 28, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Itapide-des-Chêncs, in the county of Gatineau, the territory hereinbelow described and to annex it to the school municipality of Aylmer, same county, to wit: Starting from the point of intersection of the ' northwest bank of the Ottawa river with the axis of the Fraser Road at the west line of subdivision lot 18-b of range I (1); thence, with reference to the official cadastre for the towndhip of South Hull passing by the following lines and demarcations successively, to wit: the axi of the Fraser Road running northward to the axis of the Aylmer Road, the said axis of the Aylmer Road running northeastward to the east line of subdivision lot 18-b, range I, running southward along the east line of subdivision lot 18-b, range I, to the northeast point of intersection of the Ottawa river with the axis of Foley Road, tlîence, along the shore of Lake Deschênes to the point of intersection of the northwest bank of the Ottawa river with the axis of the Fraser Road.0.J.DESAULNIERS, 32694-22-2 Superintendent of Education.No.517-52 Quebec, May 26, 1952.Application is made to detach from the school municipality of the parish of St-Nazaire-d'Acton in the county of Bagot, the part of lot No.1358, of the official cadastre for St-Nazaire-d'Acton, and to annex it to the school municipality of the Village of St-Nazaire-d'Acton, same county.O.J.DESAULNIERS, 32695-22-2 Superintendant of Education.No.464-52.Quebec, May 28, 1952.Application is made to detach from the Protestant school municipality of Wcst-Hatley, in the county of Stanstcad, the following territory, to annex it to the school municipality of the Village of Hatley in the same county, and such for Protestant tax-payers only.Said territory is described as follows, to wit: Starting at a point situate on the north limit of the municipality of the Village of Hatley, where the line between ranges II and III meets the line between lots 6 and 7; thence towards the north along the line between ranges II and III as far as the line between lots 12 and 13;thence towards, the east, following this line as far as the east limit of the municipality of VVest-Hatley Township; thence, towards the south, along the said limit, as far as the limit of the municipality of the village of Hatley; thence towards the west, following said limit between subdivision 87 on the south and subdivisions 89 and 90 on the north as far as the line between ranges I and II; thence towards the south, along this line and following the limit, of Hatley Village as far as the line between lots 6 and 7; thence, westward, following this line as far as the line between ranges II and III, the starting point.O.J.DESAULNIERS, 32689-22-2 Superintendent of Education.No.339-51 Quebec, May 28, 1952.Application is made to form into a.separate school municipality, for Protestant taxpayers only, under the name of \"The Protestant School 1468 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 23 palité scolaire protestante de St-Laurent\", dans Municipality of St-Laurent\", in the county of le comté de Jacques-Cartier, le territoire ci-des- Jacques-Cartier, the territory hereinafter descri-sous décrit, savoir: bed, to wit: Les lots suivants, des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Laurent, savoir: a) 36, 37, 48, 41, 42 et 43.6) 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263.c) 351, 352 et 266.d) 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 368, 374, 375, 406, 407 et 408.e) 364, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 3S1, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448.449, 450, «451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 et 464./) 409, 466, 4(57.468, 469.470.471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 et 4S3.g) P.73, P.77, P.78, P.82, P.83, P.84 P.85, P.S6.P.87, P 88, P.89.P.96, P.97, P.103, P.104, P.105 P.106, P.107 P.108, 109, 110, P.111, 113, P.114, P.116, 117, 118 P.119, P.123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 et 140.h) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 et 158.t) 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180.181.182, 183, 189, 190, 191 et 192.j) 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.201, 202, 203.204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 125, 216, 217, 218, 219, 220, 221.222, 223, 224, 225, 226, 227.228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235.k) 484, 486 et 487.I) 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498.499, 500.501, 502, 503, 504 et 506.m) 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570.571 et 572.n) 93.94, 95, P.96, P.97, 98, 99.100, 101, 102, P.103, P.104, P.105, P.106, P.107.P.108, P.109, P.110, P.111, P.112, P.114, 115, P.116, P.119, 120, 121, 122 et P.123.o) 2632, 2633 et 2634.Le Surintendant de l'Instruction publique.32607-22-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 555-51.Québec, le 28 avril 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Odile-sur-Rimouski, dans le comté de Rimouski, le territoire ci-dessous décrit, et de l'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"Paroisse de Saint-Ger-main-de-Rimouski\", dans le même comté, savoir: Un territoire situé dans la seigneurie de Rimouski, comprenant en référence au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimous-ki, tous les lots ou parties de lots et leurs subdivisions, présentes et à venir ainsi que les chemins, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant du sommet de l'angle ouest du lot 363; de là, passant successivement par les lignes suivantes en continuité les unes des autres: une The following lots, of the official plan and in the book of reference for the parish of Saint-Laurent, namely: a) 36, 37, 48*41, 42 and 43.b) 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263.c) 351, 352 and 266.d) 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 368, 374, 375, 406, 407 and 408.e) 364, 365, 369.370, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 3S9, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 and 464./) 409, 466.467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 4S0 que 483.g) Pt.73, Pt.77, Pt.78, Pt.S2, Pt.83, Pt.84, Pt.85, Pt.86, Pt.87, Pt.88, Pt.89, Pt.96, Pt.97, Pt.103, Pt.104, Pt.105, Pt.106, Pt.107, Pt.'108, 109, 110, Pt.Ill, 113, Pt.114, Pt.116, 117, 118, Pt.119, Pt.123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 and 140.h) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151.152, 153, 154, 155, 156, 157 qnd 158.i) 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 183, 189, 190, 191 and 192.;) 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215.216, 217, 218.219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235.k) 484, 486 and 487./) 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500.501, 502, 503, 504 and 506.m) 560.561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568.569, 570, 571 and 572.n) 93, 94, 95, Pt.96, Pt.97, 98, 99, 100, 101, 102, Pt.103, Pt.104, Pt.105, Pt.106, Pt.107, Pt.108, Pt.109, Pt.110, Pt.Ill, Pt.112, Pt.114, 115, Pt.116, Pt.119, 120, 121, 122 and Pt.123.o) 2632, 2633 and 2634.O.J.DESAULNIERS, 32697-22-2 Superintendent of Education.No.555-51.Quebec, April 28, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Stc-Odile-sur-Rimouski, in the county of Rimouski, the territory hereinbelow described, and to erect it into a separate school municipality, under the name of \"Parish of Saint-Germain-de-Rimouski\", in the same county, to wit: A territory situate in the Rimouski Seigniory, comprising, with reference to the official cadastre for the parish of Saint-Germain-de-Rimouski, all the lots or parts of lots and their present and future subdivisions and also the roads watercourses or parts of same enclosed within the following boundaries, to wit: Starting from the summit of the west comer of lot 363; thence passing by the following lines successively; a broken line separating range I QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.8J\u201e No.23 1469 ligne brisée séparant le rang I du rang II jusqu'à la ligne separative des lots 400 et 402; cette dernière ligne; une ligne séparant l'es lots 402, 404, 106, 408, 412, 414, et 415 d'un côté, des lots 401, 403, 405, 407, 411 et 413 de l'autre côté et traversant les lots 409, 417, 420, 421 et 422; la ligne nord-est des lots 422, 419 et 418; une ligne brisée limitant vers le sud-est les lots 418, 416, 413, 411, 409, 407, 405, 403, 401 et 400; la ligne nord-est du lot 423; une ligne brisée séparant les rangs III et V jusqu'à la ligne separative des lots 452 et 453; ladite ligne separative des lots 152 et 453 et enfin la ligne separative des lots 362 et 363 jusqu'au point de départ; ainsi que l'Ile St-Barnabé située dans le Meuve St-Laurent, en face du territoire de la Ville de Rimouski et comprenant en référence au même cadastre les lots 543, 544, 545 et 54(5.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32754-23-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 37-49 Québec, le 31 mai 1952.Demande est faite (pie le territoire ci-dessous décrit, soit érigé en une municipalité scolaire distincte, pour les contribuables protestants seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire protestante de Laurcntia\", dans le comté de Terrebonne: Ce territoire comprend: la partie de la municipalité de Saint-Jérôme.Rivière Nord, au sud des lots 607, 593, 576, 400, 312 et 285; la ville de St-Jérôme; la paroisse de Stc-Sophie, qui comprend les municipalités scolaires protestantes de Scotland et du Village de New-Glasgow.Ces parties des comtés de l'Assomption et de Montcalm qui furent unies à Ste-Sophie-de-New-Glasgow les 7 mai 1900 et 20 novembre 1926.Ces dernières parties comprennent la municipalité de Saint-Lin, comté de l'Assomption et la municipalité de Kilkenny, comté de Àrontcalm, à l'exception des lots suivants qui appartiennent à la municipalité scolaire protestante de Saint-Ilippolytc, savoir: Rang V St-Calixte, 26b, 27a.27b, 28b.Rang VI St-Calixte, 19a, 20c, 20d.21c.24a, 25a, 25b.26a, 26b, 27a, 27b, 28a, 28b.29a, 29b, 30, 20b, 21a.21b.Rang VII St-Calixte, 22b, 23a.23b, 24a, 24b.25a, 25c, 25d.26a, 26b, 27a.28,29a.Rang VIII St-Calixte, 16a.Rang IX St-Calixte.17a, 17b, 17c.17b part.Rang X St-Calixte, 7b, S.Rang XI St-Calixte, 17a, 17b.Aussi 20b.21b.rang VII St-Calixte.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32755-23-2-q O.J.DESAULNIERS.ERRATUM N° 339-51 Québec, le 4 juin 1952.> Dans l'avis publié dans la Gazette Officielle de Québec du 31 mai 1952, concernant la municipalité scolaire protestante de Ville St-Laurent, dans la quatrième ligne il faut enlever le mot \"Ville\" et dans la cinquième ligne remplacer le mot du par le.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32764-0 O.J.DESAULNIERS.from range II as far as the division line of lots 400 and 402; this last line; a line separating lots 402, 404, 406, 4()N, 112, 414 and 415 on one side, from lots 401, 403, 405, 407, 411 and 413 on the other side and crossing lots 409, 417, 420, 421 and 422; the northeast line of lots 422, 419 and 418; a broken line bounding on the southeast lots 418, 416, 413, 411, 409, 407, 405, 403, 401 and 400; the northeast line of lot 423; a broken line separating ranges III and V up to the division line of lots 452 and 453; the said division line of lots 452 and 453 and finally the division line of lots 362 and 363 to the starting point; also St.Barnabe Island (Ile St-Barnabé) situate in the St.Lawrence river, opposite the territory of the Town of Rimouski and comprising with reference to the same cadastre, lots 543, 544 545 and 546.0.J.DESAULNIERS.32754-23-2-o Superintendent of Education.No.37-49 Quebec.May 31, 1952.Application is made to erect the territory hereinbelow described into a separate school municipality for the Protestant taxpayers only, under the name of \"The Protestant School Municipality of Laurentia\", in the county of Terrebonne: This territory comprises: that part of the municipality of Saint-Jérome, \"Rivière Nord\", south of lots'607, 593, 576, 400.312 and 285; the town of St-Jérome; the parish of Ste-Sophie, which comprises the protestant school municipalities of Scotland and the village of New-Glasgow.These parts of the counties of L'Assomption and of Montcalm which were united to Ste-Sophie-of-New-Glasgow on Mav 7, 1900 and November 20, 1926.These latter parts comprise the municipality of Saint-Lin, county of L'Assomption and the municipality of Kilkenny, county of Montcalm, with the exception of the following lots which belong to the Protestant school municipality of Saint-Hippolvte, namely: Range V St-Calixte.26b, 27a, 27b, 28b.Range VI St-Calixte.19a, 20c, 20d, 21e, 24a, 25a.25b, 26a.26b, 27a, 27b.28a, 28b, 29a, 29b, 30, 20b, 21a, 21b.Range VII St-Calixte, 22b, 23a, 23b, 24a, 24b, 25a.25c, 25d, 26a, 26b, 27a.28, 29a.Range VIII St-Calixte, 16a.Range IX St-Calixte, 17a, 17b, 17c, 17b part.Range X St-Calixte, 7b, 8.Range XI St-Calixte, 17a, 17b.Also 20b, 21b, range VII St-Calixte.O.J.DESAULNIERS, 32755-23-2 Superintendent of Education.ERRATUM No.339-51 Quebec, June 4, 1952.In the notice published in the Quebec Official Gazette of the 31st of May 1952, concerning the Protestant School Municipality of the Town of St-Laurent, in the fourth line the word \"Town\" is deleted and in the fifth line of the French text, please replace the word \"du\" by the word \"le\".O.J.DESAULNIERS, 32764 Superintendent of Education. 1470 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1052, Tome 8>\u201e N° 23 Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoinc-de-Longucuil (maintenant partie de la ville de Jacques-Cartier), division d'enregistrement de Chambly Avis est par la présente donné que les lots 21-1 à 21-5, 21-7 à 21-19, 21-21 à 21-29, 21-31 à 21-52, 21-54 à 21-71.21-74 à 21-85, 21-89 à 21-95, 21-103 à 21-112, 21-114 à 21-120, 21-128 à 21-143, 21-145 à 21-103, 21-105 à 21-171, 21-174 à 21-185, 21-188 à 21-213, 21-215 à 21-264, 21-266 à 21-292, 21-295 à 21-313, 21-315 à 21-345, 27-1A à 27-8A, 27-10A à 27-ISA, 27-19A à 27-22A, 27-24A à 27-30A, 27-32A, 27-33A, 27-36A, 27-48A à 27-51A sont annulés en vertu de Particle 2174A du Code civil.Québec, le 14 mai 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Soux-ministre, 32748-o AVILA BÉDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of St.Antoine-de-Longueuil (now part of lot town of Jacques Cartier), registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 21-1 to 21-5.21-7 to 21-19, 21*-21 to 21-29, 21-31 to 21-52, 21-54 to 21-71, 21-74 to 21-85, 21-89 to 21-95.21-103 to 21-112, 21-114 to 21-126, 21-128 to 21-143, 21-145 to 21-163, 21-165 to 21-171, 21-174 to 21-185, 21-188 to 21-213, 21-215 to 21-264, 21-266 to 21-292, 21-295 to 21-313, 21-315 to 21-345, 27-1A to 27-8A, 27-1 OA to 27-15A, 27-19A to 27-22A, 27-24A to 27-30A, 27-32A, 27-33A, 27-36A, 27-48A to 27-51A are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil ('ode.Quebec, May the 14th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD.32748-o Deputy Minister.Département du Travail Avis d'Approbation de Règlements L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus dé Québec 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements du Comité paritaire de l'Industrie du meuble de Québec, établi en exécution du décret numéro 505 du 7 mai 1952.et dont le siège social est situé à Montréal, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 682 du 4 juin 1952, section \"D\".Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, 7 juin 1952.32747-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 411 du 17 avril 1952, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ledit décret comme suit: Le paragraphe \"//' de l'article I (juridiction territoriale) sera remplacé par le suivant: \"b) Les comtés de Deux-Montagnes, Vau-dreuil.Soulanges, Beauharnois, Chftteauguay, Laprairie, Verchercs et Chambly;\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, L'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 7 juin 1952.32747-0 Department of Labour Notice of Approval 6f By-laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), that the constitution and by-laws of the Joint Committee of the Furniture Industry of Quebec, formed under the decree number 505 of May 7th., 1952, and whose corporate seat is in Montreal, have been approved by Order in Council number 682 of June 4, 1952, part \"D\".( i ÊRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 7.1952.32747-0 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.19-11, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry and trades in the district of Montreal rendered obligatory by the decree number 411 of April 17, 1952, have submitted to him a petition to amend the said decree, as follows: Subsection \"6\" of section I (Territorial jurisdiction) will be replaced by the following: \"/;) The counties of Deux-Montagnes, Vau-dreui, Soulanges, Beauharnois.Chftteauguay, Laprairie, Verchères and Chambly\"; During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties mav wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec.June 7.1952.32747-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.June 7th, 1952, Vol.g&JVo.23 1471 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.lt.Q.1041, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans les comtés de Terre-bonne et Labelle, rendue obligatoire par le décret numéro 057 du 13 mai 1948, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: Le paragraphe \"c\" de l'article XI sera remplacé par le suivant: \"e) Pour le métier de charpentier-menuisier, il ne doit y avoir qu'un apprenti par deux (2) compagnons ou fraction de ce nombre; pour le métier de peintre, il ne doit y avoir qu'un apprenti par deux (2) compagnons ou fraction de ce nombre; cependant, pour le métier de peintre, il peut y avoir un compagnon junior et un a-prenti par deux (2) compagnons, mais jamais deux apprentis.Le peintre compagnon junior est un peintre qui a quatre (4) années d'apprentissage mais qui ne détient pas encore un certificat de qualification senior.Il ne peut exercer son métier seul; il doit toujours être accompagné d'un peintre compagnon senior.Il est entendu qu'aucun employeur ne peut faire travailler un apprenti ou compagnon peintre junior seul et qu'aucun apprenti ou compagnon peintre junior ne peut travailler à l'exécution de travaux de métier seul; il doit toujours être accompagné d'un ouvrier qualifié compagnon de son métier\".Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec le 7 juin 1952.32747-0 AVIS DE MODIFICATION Conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), l'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes qu'il a l'intention de proposer l'approbation des modifications suivantes du décret numéro 140 du 27 février 1952, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes.Terrebonne et Laval.a) Au paragraphe \"a\" de l'article IV (Durée du travail) : 1° Les dispositions suivantes seront ajoutées à l'alinéa concernant les barbiers, dans le comté de Laval : \"Toutefois, dans la ville de Ste-Rose, les heures de travail seront celles décrétées par règlement du Conseil municipal.\" 2° Les alinéas \"i\" et \"ii\" concernant la durée du travail pour les barbiers dans le comté de Terrebonne seront remplacés par les suivants: \"i.Dans les limites des villes de Terrebonne et Ste-Agathe-des-Monts et des municipalités de St-Jovite, St-Sauveur-des-Monts, Mont-Rolland et Val Morin, les heures de travail seront celles décrétées par règlement du Conseil municipal.\" NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry in the counties of Terrebonne and Labelle, rendered obligatory by the decree number 057 of May 13, 1948, have submitted to him a request to amend the said decree, as amended, as follows: Subsection \"c\" of section XI will be replaced by the following: \"c) In the carpenter-joiner's trade, there shall be but one apprentice to two (2) journeymen or fraction thereof.In the painter's trade, there shall be but one apprentice to two (2) journeymen or fraction thereof; in this trade, however, the employer may have one junior journeyman and one apprentice per two (2) journeymen, but not two apprentices.The junior journeyman painter is a painter with four (4) years of apprenticeship who does not yet hold a senior's certificate of competency.He shall not work alone, but under the direction of a senior journeyman painter.It is agreed that no employer shall cause an apprentice or junior journeyman painter to work alone and that no apprentice or junior journeyman painter shall execute tradework alone; he shall always be accompanied by a skilled journeyman painter.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 7 L952.32747-0 NOTICE OF AMENDMENT Pursuant to the procedure established under section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that he intends to recommend the approval of the following amendments to the decree number 140 of February 27, 1952, relating to the barber and hairdressing trades in Argcnteuil, Dcux-Montagnes, Terrebonne and Laval counties.a) In subsection \"a\" of section IV (Hours of work) : 1.The following provisions will be added to the paragraph concerning barbers in the county of Laval: \"However, in the town of Stc-Rose, the hours of work shall be those established by the Municipal Council.\" 2.Paragraphs \"i\" and \"ii\" concerning the duration of work for barbers of the county of Terrebonne will be replaced by the following: \"i.Within the limits of the towns of Terrebonne and Ste-Agathe des Monts and the municipalities of St.Jovite, St.Sauvcur-des-Monts, Mont-Rolland and Val Morin, the hours of work shall be those established by the Municipal Council.\" 1472 QAZETTQQFF1C1ELLE DE QUÉBEC, Quebec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 23 \"ii.Dans les municipalités de Ste-Adèlc et Shawbridge, le travail pourra se terminer à 7.00 p.m., les lundi, mardi et jeudi et à 9.00 p.m.le samedi.\" \"iii.Dans la ville de Ste-Thérèse, le travail pourra se terminer à 9.00 p.m., les jeudi et vendredi.\" 3° Les dispositions suivantes seront ajoutées à l'alinéa concernant les barbiers dans le comté d'Argenteuil: \"Toutefois, dans la municipalité de Browns-burg, les heures régulières de travail seront celles décrétées par règlement du Conseil municipal.\" 4° Les dispositions suivantes seront ajoutées à l'alinéa concernant les barbiers dans le comté de Deux-Montagnes: \"Toutefois, dans les municipalités de St-Joseph-du-Lac, St-Augustin, Stc-Monique et Stc-Scholastique, les heures de travail seront les suivantes: Les lundi et mardi: de 8.00 a.m.à S.OO.p.m.; Le mercredi: de S.0O a.m.à midi; Le jeudi: «le 8.00 a.m.à 7.00 p.m.; Les vendredi, samedi et veilles «le fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.\" 5° Les dispositions suivantes seront ajoutées au sous-paragraphe 2 concernant les coiffeurs et coiffeuses: \"Cependant, les heures do travail seront les suivantes dans les salons de coiffure de la cité de St-.Iérômc: Le lundi: de 9.00 a.m.à 1.03 p.m.; Les mardi et jeudi: de 0.00 a.m.à 0.00 p.m.: Les mercredi et vendredi: de 9.00 a.m.à 9.00 p.m.; Le samedi et la veille des fête-; chômées: de 9.00 a.m.à 0.O0 p.m.\" b) Le paragraphe \"b\" de l'article IV sera remplacé par le suivant: \"b) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent: i.dans la ville de Laobute, comté d'Argenteuil, et un rayon de trois (3) milles de ses limites, les heures de travail des barbiers, coiffeurs et coiffeuses doivent être conformes au règlement municipal numéro 162 de ladite ville; ii.dans les municipalités de St-Jovite, Mont-Tremblant, Lac Carré, St-Faustin, comté de Terrebonne, les heures de travail des barbiers, coiffeurs et coiffeuses sont comme suit: Le lundi: 1.00 p.m.à 6.00 p.m.Les mardi, mercredi et jeudi: 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Les vendredi et samedi: 8.00 a.m.à 9.00 p.m.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GERARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 7 juin 1952.32747-o AVIS DE PRELEVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire des métiers du bâtiment du district des Trois-Rivières, établi en exécution du décret numéro 1658, du 19 avril 1940, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 649 du 28 mai 1952, section \"G\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations \"ii.In the municipalities of Ste-Adèlc and Shawbridge, work may cease at 7.00 p.m.Monday, Tuesday and Thursday, and at 9.00 p.m.Saturday.\" \"iii.In the town of Ste-Thérèse, work may cease at 9.00 p.m.Thursday and Friday.\" 3.The following provisions will be added to the paragraph concerning barbers of the county of Argentcuil: \"However, in the municipality of Brownsburg, the regular hours of work shall be those established by the Municipal Council.\" 4.The following provisions will be added to the paragraph concerning barbers of the county of Dcux-Montagnes: \"However, in the municipalities of St-Joscph-du-Lac, St-Augustin, Ste-Moniquc and Ste-Scholastique, the hours of work shall be as follows: Monday and Tuesday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.\" Wednesday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).Thursday: 8.00 a.m.to 7.00 p.m.Friday, Saturday ami holiday eves: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.\" 5.The following provisions will be added to paragraph 2 concerning male and female hairdressers: \"However, the hours of work shall be as follows in hairdressing parlors of the city of St.Jerome: Monday: 9.00 a.m.to 1.00 p.m.Tuesday and Thursday: 9.00 a.m.to 6.00 p.m.Wednesday ami Friday: 9.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday and holiday eves: 9.00 a.m.to 6.00 p.m.\" b) Subsection \"6\" of section IV will be replaced by the following: \"b) Notwithstanding the provisions of the foregoing subsection: i.in the town of Lachute, Argentcuil county, and a radius of three (3) miles from its limits, the hours of work of barbers and male and female hairdressers shall comply with municipal bylaw No.162 of the said town; ii.in the municipalities of St-Jovite, Mont-Tremblant, Lac Carré, St-Faustin, Terrebonne county, the hours of work of barbers and male and female hairdressers shall be as follows: Monday: 1.00 p.m.to 6.00 p.m.Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday and Saturday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties mav wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Département of Labour, Quebec.June 7.1952.32747-e NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Berrettc, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Building Trades, district of Three Rivers, formed under decree number 1658, of April 19, 1940, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 49 of May 28, 1952, part \"G\", pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Québec, 1941, chapter 163 and amendments) to levy assessments upon the professional employers QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1052, Vol.S/\u201e No.23 1473 des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés : 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juin 1952 au 1er juin 1953; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels assujettis au décret doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de la rémunération qu'ils paient à\" leurs salariés assujettis au décret.b) Les salariés assujettis au décret doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ]/2 de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception Les employeurs professionnels doivent faire la perception du prélèvement imposé aux salariés assujettis au décret à même la rémunération qu'ils paient à ceux-ci et faire la remise des cotisations perçues et de leur propre pré:èvement,mensuelle-ment, au siège social du,Comité paritaire, avec un rapport préparé sur une formule spéciale fournie par le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec l'article 21 de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-anncxé, un état des recettes et des déboursés probables du Comité paritaire des métiers du bâtiment du district des Trois-Rivières, pour la période comprise entre le 1er juin 1952 et le 1er juin 1953.Le Comité Paritaire Des Métiers du Bâtiment du district des Trois-Rivières État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er juin 1952 et le 1er juin 1953.Recettes: Cotisations (}$ de 1%): Employeurs professionnels.$20,000.00 Salariés.20,000.00 * 840,000.00 Déboursés: Salaires des employés .$14,000.00 Frais de déplacement\u2014inspecteurs.4,500.00 Loyer et.éclairage.840.00 Dépenses de bureau .800.00 Frais judiciaires et professionnels .500.00 Impression, papeterie et publicité.800.00 Poste, téléphone et gélégrammcs .400.00 Frais des délégués et jetons de présence .12,000.00 Assurance et cautionnement.400.00 Divers et imprévus.5,760.00 840,000.00 Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 7 juin 1952.32747-0 and the employees governed by the said decree, according to the method land rate hereinafter mentioned : 1.Assessments The period of levy extends from June 1st, 1952, to June 1, 1953; such levy is laid as follows: a) The professional employers governed by the decree shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to 3^ of 1% of the wages paid to their employees governed by the decree.b) The employees governed by the decree shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of their remuneration.2.Mode of collection The professional employers shall collect the assessments of the employees governed by the decree from the wages paid to them, and remit same, together with their own assessments, every month, to the office of the Parity Committee, with a report made on a special form supplied by the Parity Committee.3.Finan-ial report Pursuant to section 21 of the Collective Agreement Act, the Parity Committee, shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial operations on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Building Trades, district of Three Rivers for the period between June 1st, 1952 and June 1st, 1953.Joint Committee of the building Trades district of Three Rivers Estimate of the receipts and disbursements for the period between June 1st, 1952 and June 1st, 1953.Receipts: Assessments (Yi of 1%) : Professional employers.$20,000.00 Employees.20,000.00 40,000.00 Expenses: Salaries of employees.14,000.00 Travelling expenses, inspectors.4,500.00 Rent and lighting.840.00 Office expenses.800.00 Judicial and professional fees.500.00 Printing, stationery and publicity.800.00 Postage, telephone and telegrams.400.00 Expenses of delegates and Meeting expenses.12,000.00 Insurance and surety-bond.400.00 Miscellaneous.5,760.00 40,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 7, 1952.32747-o 1474 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952.Tome S/t, N° 23 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre «lu Travail, donne avis par les présentes, cpie le Comité paritaire des Arts graphiques du Sague-nay, établi en exécution du décret numéro 1414 du 14 décembre 1919, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro (549 du 28 mai 1952 (section \"E\"), le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 103 et amendements) à prélever des cotisations des employeurs professionnels, «les artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après décrits: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juin 1952 au 1er juin 1953; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionels régis par le«lit décret numéro 1414 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.ft b) Les artisans régis par ledit décret numéro 1414 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à H «le 1 % du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $0.25 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 1414 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 3^ de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être intliqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 «lu mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier 0 D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes, 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des Arts Graphi- NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that \"Le Comité paritaire des Arts graphiques du Sagucnay\", established under decree No.1414 of December 14, 1949, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.049 of May 28, 1952 (part \"E\"), in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by said decree, according to the method and rate hereafter described: 1.Assessment The period of levy extends from June 1st, 1952 to June 1st, 1953, such levy shall apply as follows: a) Every professional employer governed by the decree number 1414 shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of their payroll for the employees governed by the said decree.b) All artisans governed by the said decree, number 1414, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of the wages established in the decree for the journeyman receiving the lowest pay, i.e.$0.25 per week.c) Every employee governed by the said decree, number 1414, shall pay to the Parity Committe an amount equivalent to Y of 1% of his remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the said Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete his report, sign and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments imposed on the employees by means of a deduction from the latter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or geforc the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirablc; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments imposed by the present bylaw are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, five days notice shall be given to fulfil obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuant of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the \"Comité paritaire des * QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1052, Vol SA, No.23 1475 ques % per annum, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 850.500.00 \u2014 20 years Year Capital Mav 1st, 1953.\" $1.500.00 Mav 1st, 1954.2,000.00 Mav 1st, 1955.2,000.00 May 1st, 1956.2,000.00 May 1st, 1957.2,000.00 Mav 1st, 1958.2,000.00 Mav 1st.1959.2.000.00 Mav 1st, i960.2,500.00 May 1st, 1961.2,500.00 May 1st, 1962.2,500.00 May 1st, 1963.2,500.00 May 1st, 1964.2,500.00 May 1st, 1965.2,500.00 May 1st, 1966.3.000.00 May 1st, 1967.3.000.00 May 1st, 1968.3,000.00 Mav 1st, 1969.3,000.00 Mav 1st, 1970.3,000.00 Mav 1st.1971.3,500.00 Mav 1st.1972.3.500.00 Capital and interest are payable at the principal office of a chartered bank, in the cities of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.8/,.No.28 1485 cités de Montréal et de Québec, ou à la même banque à Waterloo, comté de Shefford.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue jeudi, le 26 juin 1952, à 8 heures p.m., à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, à Waterloo, comté de Shefford.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.Waterloo, (Comté de Shefford), ce 2 juin 1952.Le Secrétaire-trésorier, GUY GENEST.Hôtel de Ville.CP.60, Waterloo.(Cté Shefford), P.Q.32725-0 Province de Québec Village de Cap-Chat (Comté de Gaspé-Nord) Montreal and Quebec, or at the same bank, in Waterloo, county of Shefford.The said bonds are.under the authority of Chapter 212.Revised Statutes of Quebec 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a metting of the Council to be held on the 26th day of the month of .June, 1952, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of Waterloo, county of Shefford.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Waterloo, (County of Shefford), this 2nd of June.1952.GUY GENEST, Secretary-Treasurer.Town Hall, P.O.Box 60, Waterloo, (Co.of Shefford), P.Q.32725-o Province of Quebec Village of Cap-Chat (County of Gaspé-North) Avis public est par les présentes dorme que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Sylva Côté, secrétaire-trésorier, Cap-Chat, comté de Gaspé-Nord, jusqu'à 8 heures p.m., jeudi, le 26 juin 1952, pour l'achat de 8210,000.00 d'obligations de la corporation du village de Cap-Chat, comté de Gaspé-Nord, datées du ler'juillct 1952 et remboursables par séries du 1er juillet 1953 au 1er juillet 1967 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 5% par année payable semi-annuellemcnt les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission où il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 9210,000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1er juillet 1953 .x 8 7,000.00 1er juillet 1954 .x 7,500.00 1er juillet 1955 .x 7,500.00 1er juillet 1956 .x 8,000.00 1er juillet 1957 .3,500.00 1er juillet 1958 .3,500.00 1er juillet 1959 .4,000.00 1er juillet 1960 .4,000.00 1er juillet 1961 .4,500.00 1er juillet 1962 .4,500.00 1er juillet 1963 .4,500.00 1er juillet 1964 .5,000.00 1er juillet 1965 .5,000.00 1er juillet 1966 .5,500.00 1er juillet 1967.136,000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $20,000.00 accordé par le Département des Travaux Publics et payable en quatre versements de $5,000.00 chacun, de 1953 à 1956 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Cap-Chat.Publie notice is hereby given that scaled tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Sylva Côté, secretary-treasurer, Cap-Chat, county of Gaspé-North, until 8 o'clock P.M., Thursday, June 26, 1952, for the purchase of an issue of $210,000.00 of bonds of the Corporation of the Village of Cap-Chat, County of Gaspé-North, dated the 1st of July, 1952, and redeemable serially from July 1, 1953, to July 1, 1967 inclusively, with interest at a rate not exceeding 5% per annum, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 9210,000.00 \u2014 15 years Year Capital July 1st, 1953 .x 8 7.000.00 July 1st, 1954 .x.7,500.00 July 1st, 1955 .x 7,500.00 July 1st, 1956 .x 8,000.00 July 1st, 1957 .3,500.00 July 1st, 1958 .3,500.00 Julv 1st, 1959 .4,000.00 July 1st, 1960 .4,000.00 July 1st, 1961 .4,500.00 July 1st, 1962 .4,500.00 July 1st, 1963 .4,500.00 July 1st, 1964 .5,000.00 July 1st, 1965 .5,000.00 July 1st, 1966 .5,500.00 July 1st, 1967 .136,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $20,000.00 granted by the Department of Public Works and payable in four instalments of $5,000.00 each, from 1953 to 1956 includively, will be received and applied to the service of this loan.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Cap-Chat. 1480 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1052, Tome 84, N° 23 Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque .soumission devra être accompagnée d'un chèque égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue le jeudi 26 juin 1952, à 8 heures p.m., à la salle municipale de Cap-Chat, comté de Gaspé-Nord.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Cap-Chat (Comté de Gaspé-Nord), ce 4 juin 1952.Le Secrétaire-trésorier, SYXVA COTÉ.Cap-Chat, (Cté Gaspé-Nord), P.Q.32760-o The said bonds are, under the authority of , Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on the Thursday, June 26, 1952, at 8 o'clock P.M., in the municipal hall of Cap-Chat, county of Gaspé-North.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Cap-Chat (County of Gaspé-North), June 4, 1952.SYLVA COTÉ, Sec retary-Trcasu rer.Cap-Chat, (County Gaspé-North), Que.32060 Province de Québec Commission scolaire de St-Laurent (Comté de Jacques-Cartier) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Louis-L.Deguire, secrétaire-trésorier, 209 Blvd Décarié, St-Laurent, Cté Jacques-Cartier jusqu'à S heures p.m., mercredi, le 25 juin 1952, pour l'achat de 81,225,000 d'obligations de la commission scolaire de St-Laurent, comté de Jacques-Cartier, datées du 1er juillet 1952 et remboursables par séries du 1er juillet 1953 au 1er juillet 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 4^% par année payable scmi-annuellcment les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 S1.225,000 \u2014 20 ans Année Capital 1 er juillet 1953.x 854.500.00 1er juillet 1954.x 57,000.00 1er juillet 1955.x 59,500.00 1er juillet 1956.x 62.500.00 1er juillet 1957.x 65,500.00 1er juillet 1958.x 68,000.00 1er juillet 1959.x 71,500.00 1er juillet 1960.x 74,500.00 1er juillet 1961.x 77,500.00 1er juillet 1962.x 81,000.00 1er juillet 1963.45,000.00 1er juillet 1964 .47,000.00 1er juillet 1965.49,000.00 1er juillet 1966.51,500.00 1er juillet 1967.53.500.00 1er juillet 1968.56,000.00 1er juillet 1969.59.000.00 1er juillet 1970.61.500.00 1er juillet 1971.64,000.00 1er juillet 1972.67,000 00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $400,000 accordé par le Secrétaire de la province et payable en dix versements de $40,000 chacun.Province of Quebec School Commission of St-Laurent (County of Jacques-Cartier) Public notice is hereby given ¦ that sealed renders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Louis L.Deguire.secretary-treasurer, 209 Blvd.Décarie, St-Laurent, Co.Jacques-Cartier, until S o'clock p.m., Wednesday, June 25, 1952, for the purchase of an issue of $1,225,000 of bonds of the School Commission of St-Laurent.County of Jacques-Cartier, dated July 1st, 1952 ami redeemable serially from 1st July 1953, to 1st July 1972, inclusively, with interest at a rate not exceeding 4]/2% per annum, payable semi-annually on January 1st and July 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption - S1.225,000 \u2014 20 years Year Capital Julv 1 st.1953.x $54,500.00 Julv 1st, 1954.x 57,000.00 July 1st, 1955.x 59,500.00 Julv 1st, 1956.x 62,500.00 Julv 1st.1957.x 65,500.00 Julv 1st, 1958.x 68,000.00 Julv 1st.1959.x 71,500.00 Julv 1st.1960.x 74,500.00 July 1st, 1961.x 77.500.00 July 1st, 1962.x 81,000.00 Julv 1st, 1963.45,000.00 Julv 1st.1964.47,000.00 Julv 1st, 1965.49,000.00 Julv 1st, 1966.51,500.00 Julv 1st, 1967.53,500.00 Julv 1st, 1968.56,000.00 July 1st,.1969.59.000.00 July 1st, 1970.61.500.00 Julv 1st, 1971.64,000.00 July 1st, 1972.67,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $400,000 granted by the Provincial Secretary and payable in ten instalments of $40.000 each, from 1953 to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1487 de 1953 à 1962 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à St-Laurent.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout OU en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 25 juin 1952, à 8 heures p.m., au bureau de la commission scolaire, à 209 Blvd Décarie, St-Laurent, comté de Jacques-Cartier.Les commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Laurent, (Comté de Jacques-Cartier), ce 30 mai 1952.Le Secrétaire-trésorier, LOUIS-L.DEGUIRE.209 Blvd Décarie, St-Laurent, (Cté Jacques-Cartier), P.Q.32726-0 Province de Québec Commission scolaire de l'Ile-Perrot-Nord (Comté de Vaudreuil) 1962 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Capital and interest arc payable at.the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at St-Laurent.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, su-jeet to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partiel redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque égal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their deli-very is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held Wednesday, June 25, 1952, at 8 o'clock p.m., at the office of the School Commission at 209 Decarie Blvd., St-Laurent, County of Jacques-Cartier.The Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Laurent (County of Jacques-Cartier), May 30, 1952 LOUIS L.DECHIRE, Secretary-Treasurer.209 Décarie Blvd., St-Laurent, (Co.Jacques-Cartier), P.Q.32726 Province de Quebec School Commission of lTle-Perrot-Nord (County of Vaudreuil) Avis public est par les présentes donné que des Public notice is hereby given that sealed ten-soumissions cachetées et endossées \"Soumissions ders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be recei-pour obligations\" seront reçues par le soussignée, ved by the undersigned Mrs.L.V.Ross, secre-Mme L.-V.Ross, secrétaire-trésorier, 273 Montée tary-trcasurer, 273 Montée Lavigne, Ilc-Perrot-Lavigne, Ile-Perrot-Nord, Cté Vaudreuil, Nord, Co.Vaudreuil, until 8 o'clock p.m., Thurs-jusqu'à 8 heures p.m., jeudi, le 26 juin 1952, day, June 26, 1952, for the purchase of an issue pour l'achat de $360,000.00 d'obligations de la of '$360,000.00 of bonds of the School Commis-commission scolaire de l'Ue-Perrot-Nord, comté sion of lTle-Perrot-Nord Co.of Vaudreuil, dated de Vaudreuil, datées du 1er juin 1952 et rembour- June 1st, 1952, and redeemable serially from June sables par séries du 1er juin 1953 au 1er juin 1972 1st, 1953 to June 1st, 1972 inclusively, with int-inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant erest at a rate not exceeding 4^% per annum, pas 4j-3% par année payable semi-annuellement payable semi-annually on June 1st and December les 1er juin et 1er décembre de chaque année.1st of each year.The rate of interest may be Le taux d'intérêt peut être le même pour toute the same for the whole issue or it may vary accord-l'émission ou il peut varier suivant les échéances, ing to maturities.The table of redemption is as Le tableau d'amortissement est le suivant: follows: Tableau d'amortissement \u2014 $800,000.00 \u2014 20 ans.Table of redemption \u2014 $360,000.00 \u2014 20 years Année Capital Year Capital 1er juin 1953.x $22,000.00 June 1st, 1953.x$22,000.00 1er juin 1954.x 23,000.00 June 1st, 1954.x 23,000.00 1er juin 1955.x 23,500.00 June 1st, 1955.x 23,500.00 1er juin 1956.x 24,000.00 June 1st, 1956.x 24,500.00 1er juin 1957.x 24,500.00 June 1st, 1957.x 24,500.00 1er juin 1958.x 25,000.00 June 1st, 1958.x 25,000.00 1er juin 1959.x 25,500.00 June 1st, 1959.x 25,500.00 1er juin 1960.x 26,000.00 * June 1st, 1960.x 26,000.00 1er juin 1961.x 26,500.00 \" June 1st, 1961.x 26,500.00 1er juin 1962.x 27,000.00 June 1st, 1962.x 27,000.00 1er juin 1963.9,000.00 June 1st, 1963.9,000.00 1er juin 1964.9,500.00 .lune 1st, 1964.9,500.00 1er juin 1965.10,000.00 June 1st, 1965.!.10,000.00 1er juin 1966.10,000.00 June 1st, 1966.10,000.00 1er juin 1967.10,500.00 June 1st, 1967.10,500.00 1er juin 1968.11,500.00 June 1st, 1968.11,500.00 1er juin 1969.12,500.00 June 1st, 1969.12,500.00 1er juin 1970.13,000.00 June 1st, 1970.13,000.00 1er juin 1971.13,000.00 June 1st, 1971.13,000.00 1er juin 1972.14,000.00 June 1st, 1972.14,000.00 1488 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952.Tome 84, N° 23 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $202,577.91, accordé par le Secrétaire de la province et payable en un versement de 820,257.80 et neuf versements de S20,257.79 chacun, de 1953 à 1902 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Le capital et les intérêts sont payables au bureau principal d'une banque à charte dans les cités de Montréal et Québec ou à la même banque à Ste-Anne-de-Bellevue.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au .pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 26 juin 1952, à 8 heures p.m., à l'école de la Petite-Cote, Boulevard Perrot, Ue-Perrot-Nord, comté de Vaudreuil.Les 'commissaires se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ile-Perrot-Nord, (Comté de Vaudreuil), ce 30 mai 1952.Le Secrétaire-trésorier, Mme L.-V.ROSS.273, Montée Lavignc, Ue-Perrot-Nord, (Cté Vaudreuil), P.Q.32761-o The letters \"x\" indicate the years dnriug which annual payments of a total amount of $202,577.91 granted by the Provincial Secretary and payable in one instalment of $20,257.80 and nine instalments of $20,257.79 each, from 1953 to 1962 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Capital and interest are payable at the bead office of a chartered bank in the cities of Montreal and Quebec or at the same bank at Stc-Anne-dc-Bcllevue.The said bonds arc, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not.in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday, June 26, 1952, at 8 o'clock p.m.at the school of the \"Petite-Côte, Boulevard Perrot, Ile-Perrot-Nord, county of Vaudreuil.The Commissionners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Ile-Perrot-Nord, (County of Vaudreuil), May 30, 1952.Mrs.L.V.ROSS, Secretary-Treasurer.273, Montée Lavigne, Ile-Perrot-Nord, (Co.Vaudreuil) P.Q.32761 Province de Québec Ville d'Abestos (Comté de Richmond) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-H.-L.Olivier, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, C.P.20, Abestos, Cté Richmond, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi, le 25 juin 1952, pour l'achat de $130,000 d'obligations de la ville d'Abestos, comté de Richmond, datées du 1er mai 1952, et remboursables par séries du 1er mai 1953 au 1er mai 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 4)4% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant : Province of Quebec Town of Asbestos (County of Richmond) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-H.-L.Olivier, secretary-treasurer.Town Hall P.O.B.20, Asbestos.Co.Richmond, until 8 o'clock p.m., Wednesday, June 25, 1952, for the purchase of an issue of $130,000 of bonds of the town of Asbestos, Co.Richmond, dated May 1st, 1952 and redeemable serially from May 1st, 1953 to May 1st, 1972 inclusively, with interest at a rate not exceeding 4j/j% per annum, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 9130,000 \u2014 20 ans.Table of redemption \u2014 $130,000 \u2014 20 years Année Capital 1er mai 1953.$6,000.00 1er mai 1954 .6,000.00 1er mai 1955.6,000.00 1er mai 1956.6,000.00 1er mai 1957.6,000.00 1er mai 1958.6,000.00 1er mai 1959.6,000.00 1er mai 1960.6,000.00 1er mai 1961 .6,000.00 1er mai 1962.6,000.00 1er mai 1963.7,000.00 1er mai 1964.7,000.00 1er mai 1905.7,000.00 1er mai 1966.7,000.00 1er mai 1967.7,000.00 Year Capital May 1st, 1953.$6,000.00 » May 1st, 1954.6,000.00 May 1st, 1955.6,000.00 Mav 1st, 1956.6,000.00 May 1st, 1957 .6,000.00 May 1st, 1958 .6,000.00 Mav 1st, 1959.6,000.00 May 1st, 1960.6,000.00 Mav 1st, 1961.6,000.00 Mav 1st, 1962.6,000.00 May 1st.1963 .7,000.00 Mav 1st, 1964.7.000.00 May 1st, 1965.7,000.00 May 1st, 1966.7,000.00 May 1st, 1967.7,000.00 il QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.8/\u201e No.28 1489 1er mai 1968.7,000.00 1er mai 1969.7,000.00 1er mai 1970.7,000.00 1er mai 1971.7,000.00 1er mai 1972.:.7,000.00 \"Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Asbestos, comté de Richmond.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les écliéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 25 juin 1952, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville d'Asbestos, comté de Richmond.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions.Asbestos, (Comté de Richmond), ce 4 juin 1952.Le Secrétaire-trésorier, J.-H.-L.OLIVIER.Hôtel de Ville, C.P.20, Asbestos (Cté Richmond), P.Q.32759-0 May 1st, 190S.7,000.00 May 1st, 1969.7,000.00 May 1st, 1970 .7,000.00 May 1st, 1971.7,000.00 May 1st, 1972.7.000.00 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Asbestos, county of Richmond.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday June 25, 1952, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of Asbestos, County of Richmond.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Asbestos, (County of Richmond), June 4, 1952.J.-H.-L.OLIVIER, Secretarv-Treasurer.Town Hall, P.O.B.20, Asbestos, (Co.Richmond), P.Q.32759 Vente par lieitation AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement N° 20824 de la Cour, Supérieure de Terrebonne siégeant à St-Jérôme le 6 mai 1952 dont: Maurice Céré et Thérèse Céré, épouse commune en biens de Aurélien Legris, et ce dernier tant personnellement que pour autoriser sa femme, tous en leur qualité d'héritiers et légataires universels de Rose Anna Clavel et Anatole Céré, des Cité et district de Montréal sont demandeurs et Rolland Céré, en sa qualité d'exécuteur-testamentaire de Anatole Céré, Gilles Céré, Paul Céré, Yvette et Jeanne Céré, filles majeures, Rolande Céré, épouse commune en biens d?Fernand Charbon-neau et ce dernier tant personnellement que pour autoriser sa femme, tous en leur qualité d'héritiers et de légataires universels de Rose Anna Clavel et d'Anatole Céré, de Terrebonne, district de Terrebonne sont défendeurs, ordonnant la lieitation d'un immeuble désigné comme suit: \"Un emplacement en la Ville de Terrebonne lot N° 134 aux plan et livre de renvoi officiels de la Ville de Terrebonne, borné à l'ouest par le chemin à barrières de Terrebonne, à l'est par les Nos 132 et 133, au nord par le N° 133 et au sud par le N° 135; contenant 47 pieds de front sur 98 pieds dans une ligne et 92 pieds dans l'autre ligne de profondeur, formant en superficie 4465 pieds, mesure française égal à 5071 pieds anglais, et bâtisses dessus érigées.\" L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le 8 juillet 1952, Cour tenante dans la salle d'audience du Palais de Justice de St-Jérôme, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au Greffe Sale by Lieitation NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment No.20824 of the Superior Court of Terrebonne, sitting at St-Jérôme on the 6th of May, 1952, whereof: Maurice Céré and Thérèse Céré, wife common as to property of Aurélien Legris, and the latter both personally and to authorize his wife, all in their quality of heirs and universal legatees of Rose Anna Clavel and Anatole Céré, of the city and district of Montreal, are plaintiffs; and Rolland Céré, as testamentary executor of Anatole Céré, Gilles Céré, Paul Céré, Yvette and Jeanne Céré, spinsters, Rolande Céré, wife common as to property of Fernand Charbonneau and the latter both personally and to authorize his wife, all in their quality of heirs and universal legatees of Rose Anna Clavel and of Anatole Céré, of Terrebonne, district of Terrebonne, are defendants, ordering the lieitation of the immovable described as follows: An emplacement in the Town of Terrebonne, lot No.134 on the official plan and in the book of reference for the Town of Terrebonne, bounded on the west by the turnpike road of Terrebonne, on the east by Nos 132 and 133, on the north by No.133 and on the south by No.135; measuring 47 feet in front by 98 feet in one line and 92 feet in the other depth line, forming a superficial area of 4465 feet, French measurement, equal to 5071 feet English measure \u2014 and with the buildings thereon erected.The above described immovable will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder, on the 8th of July, 1952, Sitting the Court, in the Court Room of the Court House of St-Jérôme, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in 1490 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome SA, N° 28 du Protonotaire do lu dite Cour; et.que toute opposition afin d'annuler, à fin de charges ou à fin de distraire à In dite lieitation, devra être déposée au Greffe du Protonotaire de la dite Cour, au inoins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et (pie toute opposition afin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent avis, elles seront forcloses «lu droit dé le faire.Montréal, le 30 mai L952.Le Procureur des demandeurs.32732-23-2-0 LORENZO CAMIRAND.the office of the Prothonotary of the said Court; and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to he made to the said lieitation, must he filed in the office of the Prothonotary of the said Court, at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; and, failing the parties to file the said oppositions within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Montreal.Mav 30, 1952, LORENZO CAMIRAND.32732-23-2 Attorneys for plaintiffs.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, est par le present donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEDFORD Canada, Province de Québec District de Bedford Fieri Facias de Bonis et de Terris N° 3972 / c RNEST W.CRAWFORD, machine l-1 niste, domicilié en la cité de Sher-( brooke, district de St-François, demandeur, vs WILLIAM S.BROCK & FREEMAN S.BROCK, tous deux fermiers domiciliés dans le canton de Potton, district de Bedford, défendeurs.Comme appartenant aux défendeurs: \"Une certaine ferme située et sise dans le canton de Potton, dans ledit district de Bedford, connue aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre dudit canton de Potton comme étant les lots de terre numéros sept cent quarante-quatre (474) et sept cent quarante-cinq (745) (sauf et à distraire un acre de terrain mesuré du coin nord-est dudit lot 744 vendu à un nommé J.A.Wright, par un acte de vente enregistré sous le numéro 47745), le résidu des dits lots contenant cent-cinquante-huit acres de terre en superficie, plus ou moins.\" Pour être vendue à la porte de l'église catholique de St-Thomas l'Apôtre à Bolton-Sud, MERCREDI, leDIX-IIUITIEME jour de JUIN à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, A.ST-MARTIN.Palais de Justice, Swectsburg, Que.Ce 12e jour de mai 1952.32613-20-2 Fieri Facias Cour d'Échiquier C T^ANS l'affaire de LA du Canada, ) U LOI FÉDÉRAL SUR N° 44981.i LES DROITS SUCCESSO-{ RAUX, in rr JOSEPH JEAN LAWRENCE E.MINTZ, anciennement de la cité de Détroit, dans l'état de Michigan, un des États-Unis d'Amérique, maintenant des cité et district de Montréal, exécuteur testamentaire de la succession de Corinne Valiquctte, autrefois de la ville de Farnham, district de Bedford, célibataire, décédé.e Comme appartenant au défendeur: Le lot N° 117 des plan et livre de renvoi officiels de la ville de Farnham, avec les bâtisses dessus érigées.Pour être vendu à la porte de l'église catholique St-Romuald de Farnham, comté de Missis- SHERIFFS' SALE PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEDFORD Canada, Province of Quebec District of Bedford Fieri Facias de Bonis et de Terris ( c RNEST W.CRAWFORD, moch-No.3972-j l-' foist domiciled in the City of l Sherbrooke, district of St.Frnacis, Plaintiff, vs WILLIAM S! BROCK & FREEMAN S.BROCK both farmers domiciled at the Township of Potton, district of Bedford, defendants.As belonging to the defendants: \"That certain farm situate and lying in the Township of Potton, in the said district of Bedford, known upon the official cadastral plan and in the book of reference of the said Township of Potton as the lots of land numbers Seven hundred and forty-four (744) and Seven hundred and forty-five (745) (save and except one acre of land measured off from the north east corner from said lot 744 sold to one J.A.Wright, as per deed of sale registered under number 47745) containing the remainder of said lots one hundred and fifty-eight acres of land in superficies, more or less.\" To be sold at the Catholic Church door of St-Thomas-1'Apôtre at South Bolton, on WEDNESDAY, the EIGHTEENTH day of JUNE, at TEN o'clock in the forenoon.A.ST-MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sweetsburg, Que.this 12th day of May 1952.32613-20-2-o Fieri Facias Exchequer Court I TN the matter of THE FE- of Canada, ) A DERAL ACT CONCER-No.44981.) NING SUCCESSION DU-{ TIES, in re: JOSEPH JEAN LAWRENCE E.MINTZ, heretofore of the city of Detroit, in the State of Michigan, one of the United States of America, now of the city and district of Montreal, testamentary executor to the estate of Corinne Valiquette, heretofore of the town of Farnham, district of Bedford, spinster, deceased.As belonging to the defendant.Lot No.117 of the official plan and book of reference for the town of Farnham \u2014 with the buildings thereon erected.To be sold at the Catholic Church door of St-Romuald de Farnham.county of Missisquoi, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1491 quoi, district de Bedford, JEUDI, le DIXIEME jour de JUILLET, MIL NEUF CENT CINQUANTE-DEUX, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, A.ST-MARTIN.Palais de Justice, Sweetsburg, le 2 juin 1952.32733-23-2-0 Canada, Province de Québec, District d'Arthabaska ( 'our Supérieure, / T\\ame ROSE-ÉVA PI-N° 6762 < -L7 GEON, ménagère demeu-l rant à Drummondville, district d'Arthabaska, veuve majeure de feu Valé-rien Laflamme, de son vivant boulanger des mêmes lieux, demanderesse, vs EMILE SURPRENANT de Drummondville, district d'Arthabaska, défendeur, et HERVÉ DESMARAIS, mis-en-cause.Comme appartenant au défendeur: o) Un certain terrain situé dans le Canton de Sutton, maintenant compris dans les limites dudit village de Sutton, tel qu'incorporé et actuellement connu comme étant la partie du coin sud-est du lot numéro (1032) mille trente-deux des Plan et Livre de Renvoi officiels dudit canton de Sutton, borné en front par la rue Principale, au sud, par lu ligne sud du dit lot restant et appartenant à Henri Desprès ou représentants légaux, la ligne est sur la dite rue Principale s'étendant du coin sud-est dudit lot jusqu'à six pieds au nord de la bfttisse-boulangcrie y érigée, la ligne nord devant aussi se prolonger à partir de la rue Principale, parallèle à la ligne sud du dit lot jusqu'à deux pieds en arrière du hangar attenant à ladite bâtisse-boulangerie, et la ligne ouest devant être parallèle à ladite rue, le tout avec les bâtisses y érigées, servant de boulangerie, logement, four, hangar, etc./;) Les ustensiles de boulangerie, les machineries de quelque nature ou description qu'ils soient et servant à l'exploitation de la boulangerie et tels que présentement installés en permanence ainsi que les deux camions de marque Ford, tels qu'équipés actuellement.Pour être vendu à la porte de l'église catholique St-André de Sutton, comté de Brome, district de Bedford.MERCREDI, le NEUVIEME jour de JUILLET, MIL NEUF CENT CINQUANTE-DEUX, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, A.ST-MARTIN.Palais-de-Justice, Sweetsburg, le 2 juin 1952.32734-23-2-o HULL District'de Hull Cour Supérieure, / \"RRNEST LAUZON, culti-N° 1640.\\ vateur, de l'endroit appelé \\ Notre-Dame de la Paix, district de Hull, demandeur, vs LES HÉRITIERS LÉGAUX DE FEU R.MARENGERE, de son vivant du Village de Pointe-Gatineau, district de Hull, défendeurs.' Un immeuble connu sous le numéro quarante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro cinq cent cinquante-quatre (554-47) «lu cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, avec les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'Église paroissiale St-François de Sales de Pointe-Gatineau, le judicial district of Bedford, on THURSDAY, the TENTH day of JULY, NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-TWO, at TEN o'clock in the forenoon.A.ST-MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sweetsburg, June 2, 1952.32733-23-2 Canada, ¦ Province of Quebec, District of Arthabaska Superior Court / r\\ame ROSE EVA PIGEON, No.6762 plaintiff ès-qualité; vs I DAME GERMAINE ROY wife separate as to property of Julien Roy, defendant.An emplacement situate at Plage Laval, county of Laval, known as lots numbers three hundred and sixty-three, three hundred and sixty-four and three hundred and sixtv-five of the subdivision of lot one hundred and eighty-five (185-363-364-365) of the official plan and book of reference for the parish of Ste-Rose \u2014 with buildings thereon erected, bearing number 112, 12th Avenue, Plage Laval. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1493 Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Théophile de Laval, (Plage Laval) le DIX-NEUVIEME jour de JUIN prochain, à ONZE heures du matin.Un dépôt de §500 sera exigé de tout offrant ou enchérisseur, suivant jugement de l'Hon.juge E.Marier, daté le 1er juin 1951.Le Shérif.Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 13 mai 1952.32611-20-2-o Fieri Facias de Terris C.S.\u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( \\ yf E T R O P O LIT A N N° 311050.-J iVJ; COAL IM P O R T \\ INC., demanderesse, vs Daine JEANNE D'ARC DAVIS, épouse séparée de biens de Ogden T.Davis, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, défenderesse.Premièrement: Un emplacement ayant front sur l'avenue Van Home au coin de l'avenue Stuart en la cité d'Outremont, formant la partie nord-est de la subdivision cent quatre-vingt-quinze du lot numéro trente-sept (37 N.E.ptie 195) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, mesurant cinquante-trois pieds et quatre pouces de largeur en front.cin-quante-trois pieds et deux pouces de largeur en arrière par une profondeur de quatre-vingt-six pieds et six pouces; borné en front vers le nord-ouest par l'avenue Van Home, en arrière vers le sud-est par une ruelle étant la subdivision cent quatre-vingt-quatorze dudit lot numéro trente-sept (37-194), d'un côté vers le nord-est par l'avenue Stuart et de l'autre côté vers le sud-ouest par le résidu de ladite subdivision cent quatre-vingt-quinze ci-après décrite en second lieu.Avec la conciergerie dessus érigée portant le N° civique 1460 avenue Van Horne, sa partie frontale sud-ouest est construite mitoyen; Ledit emplacement étant sujet au droit de passage sur une lisière de terrain ou passage de trois pieds de largeur par toute la profondeur entre la ligne arrière dudit emplacement et la ligne de côté sud-est de la cour intérieure entre la bâtisse ci-dessus décrite et celle érigée sur son côté sud-ouest, et aussi par la porte conduisant dudit passage à ladite cour intérieure, ladite cour ayant été destinée à l'usage conjoint de l'emplacement ci-dessus décrit et celui ci-après décrit en second lieu située immédiatement au sud-ouest d'icelui, pour servir à l'usage conjoint desdits emplacements respectifs, notamment pour fins de lumière et de vue et pour l'installation d'escaliers de sauvetage sur les bâtisses érigées sur lesdits emplacements; les frais d'entretien dudit passage, de la porte et de la cour intérieure seront défrayés conjointement par les propriétaires desdits emplacements, une servitude réceiproque existant à cet effet ayant été établie sur et en faveur desdits emplacements à leur bénéfice respectifs par acte de vente de Biltmore Realty and Construction Limited à Edwin S.Crabtrce passé devant Me L Kert, notaire, le quatrième jour de janvier dix-neuf cent trente et enregistré au bureau d'enregistrement de Montréal sous le numéro 234864.Avec le droit de passage en commun avec d'autres y ayant droits dans ladite ruelle en arrière.Toutes les dimensions ci-dessus sont mesure anglaise et plus ou moins.To be sold at the parochial church door of the parish of St-Théophile de Laval (Plage Laval) on the NINETEENTH day of JUNE next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.A deposit of 8500 shall be exacted from each and every bidder pursuant to a judgment of Hon.Justice E.Marier, dated June 1st, 1951.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, May 13th, 1952.32611-20-2-o Fieri Facias de Terris S.('.\u2014 District of Montreal Montreal, to wit: ( \\yfE T R O P O LIT A N No.311050.< -l-Vl 'COAL I M P O R T v.INC., plaintiff, vs Dame JEANNE D'ARC DAVIS, wife separate as to property of Ogden T.Davis, and the latter for the purposes of authorizing his wife to these presents, defendant.FirstL An emplacement fronting on Van Home Avenue at the corner of Stuart Avenue, in the City of Outremont, forming the North easterly part of subdivision one hundred and ninety-five of lot number thirty-seven (37N.E.pt.195) on the Official plan and book of Reference of the Parish of Montreal, measuring fifty-three feet and four inches in width in front, fifty-three feet and two inches in width in rear by a depth of eighty-six feet and six inches; bounded in front towards the north-west by Van Horne Avenue, in rear towards the south-east by a lane being subdivision one hundred and ninety-four of the said lot number thirty-seven (37-194), on one side towards the north-east by Stuart.Avenue, and on the other side towards the south-west by the residue of the said subdivision one hundred and ninety-five hereinafter secondly described.With the apartment building thereon erected bearing the civic No.1460 Van Horne Avenue, the south-west of the front part whereof is built mitoyen; The said emplacement being subject to the right of passage over a strip of land or passage three feet in width by the whole depth between the rear line of the said emplacement and the south-east side line of the open court between the building hereinabove described and that erected on the south-west side thereof, and also through the door leading from the said passage into the said open court, the said court having been designated for the joint use of the emplacement above described and that hereinafter secondly described situate immediately to the south-west thereof, to serve for the joint use of the said respective emplacements, primarily for the purpose of light and view and for the installation of fire-escapes on the buildings erected upon the said emplacements; the costs of maintenance of the said passage, door and open court to be at the joint expense of the said respective emplacements and the owners thereof a reciprocal servitude to that effect having been established upon and in favour of the said emplacements for the benefit of them respectively under the deed of sale from Biltmore Realty and Construction Limited to Edwin S.Crabteee, passed before Me.I.Kert, Notary, on the fourth day of January nineteen hundred and thirty, and registered at the Registry Office for Montreal under the number 234864.With the right of passage in common with others having rights therein in the said lane in rear.All the above measurements arc English measure and more or less. 1494 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1962, Tome 84, N° 23 Deuxièmement: Un emplacement ayant front sur l'avenue Van Home, en la cité d'Outremont, mesurant£cinquante-trois pieds et six pouces de largeur par quatre-vingt-six pieds et six pouces de profondeur, composé de: o) La partie sud-ouest de la subdivision cent quatre-vingt-quinze du lot numéro trente-sept (37-S.O.ptie 195), aux plan et livre de renvoi officiels de la parusse de Montréal, mesurant cinq pieds et six pouces de largeur en front et en arrière, par quatre-vingt-six pieds et six pouces de profondeur; bornée en front vers le nord-ouest par l'avenue Van Horne, en arrière, vers le sud-est, par une ruelle étant la subdivision cent quatre vingt-quatorze diidit lot numéro trente-sept (37-194), d'un côté, vers le nord-est, par le résidu de ladite subdivision cent quatre-vingt-quinze ci-dessus décrite en premier lieu et de l'autre côté, vers le sud-ouest, par la subdivision cent quatre-vingt-seize, ci-après décrite, et b) La subdivision cent quatre-vingt-seize dudit lot numéro trente-sept (37-196) aux dits plan et livre de renvoi officiels; mesurant quarante-huit pieds de largeur en front et en arrière par quatre-vingt-six pteds et six pouces de profondeur.Avec la conciergerie dessus érigée portant le No.civique 1470 avenue Van Horne, les murs nord-est et sud-ouest de sa partie frontale sont mitoyens; Avec ensemble et sujet au droit de passage sur une lisière de terre ou passage de trois pieds de largeur par toute la profondeur entre la ligne arrière dudit emplacement et de l'emplacement adjacent vers le nord-est et décrit ci-dessus en premier lieu, comprenant la partie nord-est de ladite subdivision cent quatre-vingt-quinze dudit lot numéro trente-sept, laquelle contient ledit passage et la ligne de côté sud-est de la cour intérieure entre la bfitisse dessus décrite et celle érigée sur ledit emplacement adjacent et aussi par la porte conduisant dudit passage à la dite cour intérieure, ladite cour intérieure ayant été destinée à l'usage conjoint de l'emplacement dessus décrit et à celui dessus décrit en premier lieu, et située immédiatement au nord-est d'icelui pour servir à l'usage conjoint desdits emplacements respectifs, notamment pour fins de lumière et de vue et pour l'installation d'escaliers de sauvetage sur les bâtisses érigées sur lesdits emplacements; les frais d'entretien dudit passage, de la porte et de la cour intérieure, seront défrayés conjointement par les propriétaires respectifs desdits emplacements, une servitude réciproque ayant été établie sur et en faveur desdits emplacements à leur bénéfice respectivement en vertu d'un acte enregistré sous le numéro 234864, tel que susdit.Avec le droit en commun avec d'autres y ayant droit dans ladite ruelle en arrière.Toutes les dimensions sont mesure anglaise et plus ou moins.Telles que lesdites propriétés se trouvent actuellement avec tous leurs droits, membres et appartenances, sans exception ni réserve d'aucune sorte.Pour être vendus, à mon bureau, en la cité de Montréal, le DIX-NEUVIEME jour de JUIN prochain, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 13 mai 1952.32612-20-2 Second: An emplacement fronting on Van Horn Avenue, in the City of Outremont, measuring fifty-three feet and six inches in width by eighty-six feet and six inches in depth, composed of: o) The southwesterly part of subdivision one hundred and ninety-five of lot number thirty-seven (37 S.W.Pt.195) on the official plan and in the book of Reference of the Parish of Montreal, measuring five feet and six inches in width in front and in rear by eighty-six feet and six inches in depth; bounded in front towards the north-west by Van Horne Avenue, in rear towards the south-east by a lane being subdivision one hundred and ninety-four of the said lot number thrity-seven (37-194) on one side towards the north-east by the residue of the said subdivision one hundred and ninety-five hereinabove firstly described, and on the other side towards the south-west by subdivision one hundred and ninety-six hereinafter described, and b) Subdivision one hundred and ninety-six of the said lot number thrity-seven (37-196) on the said official plan and book of Reference; measuring forty-eight feet in width in front and in rear by eighty-six feet and six inches in depth.With the apartment building thereon erected bearing the civic No.1470 Van Horne Avenue, the north-east and south-west walls of the front part whereof are built mitoyen; Together with and subject to the right of passage over a strip of land or passage three feet in width by the whole depth between the rear line of the said emplacement and of the adjacent emplacement towards the north-east hereinabove firstly described, composed of the northeasterly part of the said subdivision one hundred and ninety-five of the said lot number thirty-seven, which contains the said passage and the southeasterly side line of the open court between the building above described and that erected on the said adjacent emplacement and also through the door leading from the said passage into the said open court the said open court having been designated for the joint use of the emplacement above described and that hereinabove firstly described, and situated immediately to the northeast thereof to serve for the joint use of the said respective emplacements, primarily for the purpose of light and view and for the installation of fire-escapes on the buildings erected upon the said emplacements; the cost of maintenance of the said passage, door and open court to be at the joint expense of the said respective emplacements and the owners thereof a reciprocal servitude having been established upon and in favour of the said emplacements for the benefit of them respectively under deed registered under the number 234864 as aforesaid.With the right of passage in common with pthers having rights therein in the said lane in rear.All the above measurements are English measure and more or less.As the said properties now subsist with all their rights, members and appartenances, without exception or reserve and any kind.To be sold, at my office in the City of Montreal, on the NINETEENTH day of JUNE next, at TWO o'clock in the afternoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, May 13th, 1952.32612-20-2-O QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1495 QUÉBEC Fieri Facial.Québec, à savoir: C T A.FORTIN, epicier-N° 65347 < J \u2022 boucher licencié, domi- \\ cilié à 14 rue Lacroix, La Tuque; contre ROLAND LAROUCHE, cultivateur, domicilié à La Bostonnais, comté de Laviolette, à savoir: Le lot No 14 (quatorze) étant un lot de terre situé dans le rang nord-ouest du Canton Bourgeois, comté de Laviolette, avec le moulin à scie et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Jean Bosco, comté de Laviolette, le VINGT-SEPTIÈME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, AIMÉ DION.Québec, le 19 mai 1952.32632-21-2-0 [Première insertion: 24 mai 1952.] Deuxième insertion :7 juin 1952.] Fieri Facias.Québec, à savoir: ( T E COMPTOIR DE No 62547 < -L* CRÉDIT, LIMTÉE, \\ corporation légalement constituée, ayant son siège social à Québec; contre GERARD AUGER, de St-Pierre de Charles-bourg, comté de Québec, vendeur et propriétaire, à savoir: 1.Le lot No 13 (treize) de la subdivision Nol (un) du lot No 417 (quatre cent dix-sept) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec, étant un emplacement situé sur la rue Létourneau, mesurant 61 pieds et 10 pouces de front sur 69 pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise.2.Partie du lot No 12 (douze) de la subdivision No 1 (un) du lot No 417 (quatre cent dix-sept) du cadastre officiel dour la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec, étant un terrain situé sur la rue Létourneau, mesurant 15 pieds de front sur 69 pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise, bornée au sud-ouest par le lot No 417-1-13, au sud-est par le lot No 416, au nord-est par le résidu du dit lot No 417-1-12 et au nord-ouest par la rue Létourneau.Le tout pour être vendu \"en bloc\" avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Avec droit de passage sur la lisière de 15 pieds constituant la continuation de la rue et'étant une partie du lot No 417 non subdivisé.Pour être vendus \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de Charlesbourg, comté de Québec, le VINGT-SEPTIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif.Bureau du Shérif.AIMÉ DION.Québec, le 19 mai 1952.32633-21-2-o [Première insertion: 24 mai 1952.] Deuxième insertion: 7 juin 1952.QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit: C T A.FORTIN, licensed gro-No.65347 < J \u2022 cer-butcher, domiciled at v 14 Lacroix Street, La Tuque; against ROLAND LAROUCHE, farmer, domiciled at La Bostonnais, county of Laviolette, to wit: Lot No.14 (fourteen) being a lot of land situate in the northwest range of the township of Bourgeois, county of Laviolette, with the sawmill and other buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parish church door of St-Jean Bosco, county of Laviolette, the TWENTY-SEVENTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, May 19, 1952.32632-21-2 [First insertion: May 24, 1952] [Second insertion: June 7, 1952] Fieri Facias Quebec, to wit: / T E COMPTOIR DE No.62547 < -L* CRÉDIT, LIMITÉE, v a duly incorporated body, having its head office at Quebec; against GERARD AUGER, of St-Pierre de Charlesbourg, county of Quebec, salesman and proprietor, to wit: 1.Lot No.13 (thirteen) of subdivision No.1 (one) of lot No.417 (four hundred and seventeen), of the official cadastre for the parish of Charlesbourg, county of Quebec, being an emplacement situate on Létourneau street, measuring 61 feet and 10 inches in front by 69 feet in depth, more or less, English measure.2.Part of lot No.12 (twelve) of subdivision No.1 (one) of lot No.417 (four hundred and seventeen) of the official cadastre for the parish of Charlesbourg, county of Quebec, being a lot of land situate on Létourneau street, measuring 15 feet in front by 69 feet in depth, more or less, English measure, bounded on the southwest by lot No.417-1-13, on the southeast by lot No.416, on the northeast by the residue of said lot No.417-1-12 and on the northwest by Létourneau street.The whole to be sold \"en bloc\" \u2014 with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.With right of way over a strip of.15 feet constituting the continuation of the street and being a part of lot No.417 unsubdivided.To be sold \"en bloc\" at the parish church door of Charlesbourg, county of Quebec, on the TWENTY-SEVENTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.AIMÉ DION, Sheriff's 05ce, Sheriff.Quebec, May 19, 1952.32633-21-2 [First insertion: May 24, 1952.] [Second insertion: June 7, 1952.] RICHELIEU Fieri Facias Cour Supérieure, / A IMÉ RACINE, cultiva-N° 11467.< * \\ teur, de Verchères, dis-( trict de Richelieu, demandeur, vs niENEE CHARBONNEAU, cultivateur, des mêmes lieux, défendeur.Une terre à bois située en la paroisse de Ver-chères, au \"Grand-Côteau\", consistant en le lot connu et désigné sous le numéro six cent vingt- RICHELIEU Fieri Facias Superior Court, / A IMÉ RACINE, farmer, No.11467.< n of Verchères, district of l Richelieu, plaintiff; vs IRE-NEE CHARBONNEAU, farmer, of the same ce, defendant.A wooded lot of land, situate in the parish of Verchères, at \"Grand-Côteau\", consisting of the lot known and designated under number six 1496 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 23 deux (622) au cadastre officiel de la paroisse de Verchères, mesurant environ cinq perches de largeur, sur une profondeur de trente-huit arpents et cinq perches, sans garantie et mesure précise, bornée au nord-ouest par le numéro 621 appartenant à Aimé Racine; au sud-est par le trait-carré des terres de Verchères d'un côté, au nord-est, à Joseph McDuff et d'autre côté, au sud-ouest à la terre à bois de Aimé Langlois.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de Verchères JEUDI le DIX-NEUVIEME (19) jour de JUIN 1952, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.PAQULN.Sorel, 10 mai 1952.32609-20-2-o [Première insertion: 17 mai 1952] SAINT-HYACINTHE Fieri Facias de bonis et de Terris District de St-Hyacinthe Cour du Magistrat, (TA CORPORATION N° 13779.< -l* MUNICIPALE DU (VILLAGE DE SAINTE-HELENE, corps légalement constitué ayant sa place d'affaires au vidage de Sainte-Hélène, district de Saint-Hyacinthe, demanderesse; vs JACQUES LAFONTAINE, notaire, des cité et district de Saint-Hyacinthe, en sa qualité de cu-tateur aux biens de The Duffault Milling Company Limited, corporation éteinte suivant jugement de la Cour Supérieure du district de Saint-Hyacinthe, en date du 12 novembre 1951, défendeur; Saisi comme appartenant au défendeur ès-qualité: Un terrain situé dans la paroisse de Sainte-Hélène, sur le rang de Sainte-Hélène Ouest, de la contenance de 1 arpent de front sur un arpent de profondeur, mesure française, connu comme étant partie du lot numéro deux cent trante-neuf (ptie 239), de la paroisse de Stc-Hélène, dans le comté de Bagot; borné: en front, par la route qui conduit à la gare du chemin de fer; du côté sud-est, par partie-du même lot appartenant à la compagnie de chemin de fer; en arrière et du côté nord-ouest, par le résidu du même lot 239.Avec un moulin y érigé.Pour être vendu, à la porte de l'église paroissiale de Sainte-Hélène, dans le comté de Bagot, le DIX-HUITIEME jour de JUIN 1952, à 10.30 hres a.m.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.BOUSQUET.St-Hyacinthe, le 8 mai 1952.32591-20-2-o hundred and twenty-two (622) of the official cadastre for the parish of Verchères, measuring about five perches in width by a depth of thirty-eight arpents and five perches, without guarantee of exact measurement, bounded on the northwest by number 621, belonging to Aimé Racine, on the southeast by the \"trait-carré\" of the lands of Verchères, on one side, on the northeast, by Joseph McDuff, and on the other side, on the south-west, by the wooded lot of land of Aimé Langlois.To be sold at the parochial church door of Verchères, on THURSDAY, the NINETEENTH (19th) day of JUNE, 1952, at TEN o'clock in the forenoon.R.PAQUIN, Sheriff's Office.Sheriff.Sorel, May 10, 1952.32609-20-2 [First insertion May 17, 1952] SAINT-HYACINTHE Fieri Facias de Bonis et de Terris District of St-Hyacinthe Magistrate's Court, / HTH E MUNICIPAL No.13779.< 1 CORPORATION OF I THE VILLAGE OF SAINTE-HÉLÈNE, a body politic and corporate, having its head office in the village of Sainte-Hélène, district of Saint-Hyacinthe, plaintiff; vs JACQUES LAFONTAINE, notary, of the city and district of Saint-Hyacinthe, in his capacity as Curator to the property of the Duffault Milling Company Limited, extinct corporation, according to judgment of the Superior Court of the District of Saint-Hyacinthe, dated November 12, 1951, defendant; seized as belonging to the defendant ès-qualité: A lot of land situate in the parish of Ste-Hélè-ne, on the Sainte-Hélène West range, containing one arpent in front by one arpent in depth, French measurement, known as being part of lot number two hundred and thirty-nine (pt.239), of the parish of Ste-Hélène, in the county of Bagot, bounded: in front, by the road which leads to the railroad station; on the south-east side, by a part of the same lot belonging to the railroad company: in rear and on the northwest side, by the residue of the same lot 239, with a mill thereon erected.To be sold at the church door of the parish of Sainte-Hélène, in the county of Bagot, the EIGHTEENTH day of JUNE, 1952, at HALF-PAST TEN o'clock in the forenoon.R.BOUSQUET, Sheriff'sOffice, Sheriff.St-Hyacinthe, May 8, 1952.32591-20-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N* 23 Actions en separation de biens: Patry vs Lorange.1461 Roy vs Lavallée.1461 St-Laurent vs Laplante.1461 Action en separation de corps et de biens: Bergeron vs Couture.1461 Index of the Quebec Official Gazette, No.23 Actions for Separation as to Property: Patry vs Lorange.1461 Roy vs Lavallée.1461 St-Laurent vs Laplante.1461 Action for Separation as to Bed and Board: Bergeron vs Couture.1461 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.8/,, No.28 1497 Arrêtés en Conseil: 649, section \"A\" \u2014 Laiterie, Québec.649, section \"B\" \u2014 Horloger et bijoutier.649, section \"C\" \u2014 Imprimerie, Montréal.649, section \"F\" \u2014 Commerce de l'alimentation au détail, Québec.649, section \"H\" \u2014 Coiffeurs pour dames, Montréal.> Avis aux intéressés: Avis divers: Blue Valley Corp'n (Directeurs) .Canbanco Employees Credit Union (Fondation).Gulf Securities Corporation Limited (Directeurs).Les Magasins Fariner Ltée (Dist.de l'actif).Le Syndicat de l'U.C.C.de Maria (Formation).Le Syndicat de l'U.C.C.de New Richmond (Formation).Le Syndicat de l'U.C.C.de Saint-Edgar (Formation).Le Syndicat de l'U.C.C.de Saint-Godefroi (Formation).Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Omer (Formation).L.G.Beaubien & Cie, Limitée (Directeurs) .St-Laurent, paroisse (Durée de mandat).Syndicat des Employés de Dennison Mfg.Co.Ltd (Formation).Syndicat des Maîtres-Artisans Barbiers du District de St-François (Formation) .Syndicat National Catholique des Employés de la Granby Electric & Textile Inc.(Nom changé).Syndicat National des Maisons Préfabriquées de Québec Inc.(Terminée) The Kingsmen Club of Pointe Claire (Directeurs).The Morgan Arboretum & Woodland Development Association (Règlements) .Chartes \u2014Abandon de: Ayer's Cliff Creamery, Limited.Durieux Entreprises Inc.Groverhill Golf & Country Club Inc.La Compagnie d'Approvisionnement d'Eau Limitée.Les Produits Laitiers Laurentide Limitée.Melbrook Garment Incorporated.Sanguinet Limitée.Venus Jewellery Mfg.Ltd.Compagnie autorisée a faire des affaires: Dan River Mills, Incorporated.Compagnies dissoutes: Christie Mining Syndicate Incorporated Cowansville Realties, Limited.Darwood Mining Company.Orders in Council: 1452 649, Part \"A\" \u2014 Dairy, Quebec.1452 649, Part \"B\" \u2014 Clocmaking and je- 1454 wellery.1454 649, Part \"C\" \u2014 Printing, Montreal.1455 1455 649, Part \"F\" \u2014 Retail Food Trade, 1455 Quebec.1455 649, Part \"H\" \u2014 Ladies hairdressing, 1456 Montreal.1456 1443 Notice to Interested Parties: 1443 Miscellaneous Notices: 1458 Blue Valley Corp'n (Directors).1458 Canbanco Employees Credit Union 1456 (Foundation).1456 Gulf Securities Coiporation Limited 1460 (Directors).^.1460 Les Magasin Farmer Ltée (Dist.of 1456 assets).1456 Le Syndicat de l'U.C.C.de Maria 1460 (Formation).1460 Le Syndicat de l'U.C.C.de New Rich- 1459 mond (Formation).1459 Le Syndicat de l'U.C.C.de Saint-Edgar 1457 (Formation).1457 Le Syndicat de l'U.C.C.de Saint- 1459 Godefroi (Formation).1459 Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Omer 1459 (Formation).1459 L.G.Beaubien & Cie, Limitée (Direc- 1457 tors).1457 St-Laurent, parish, (Duration of man- 1458 date).1458 Syndicat des Employés de Dennison 1460 Mfg.Co.Ltd (Formation).1460 Syndicat des Maîtres-Artisans Barbiers du District de St-François (Forma- 1460 tion).1460 Syndicat National Catholique des Employés de la Granby Electric & Textile 1457 Inc.(Name changed).1457 Syndicat National des Maisons Préfabriquées de Québec Inc.(Termi- 1458 nated).1458 The Kingsmen Club of Pointe Claire 1457 (Directors).1457 The Morgan Arboretum & Woodland Development Association (By-1460 laws).1460 Charters \u2014 Surrender of: 1462 Ayer's Cliff Creamery, Limited.1462 1462 Durieux Entreprises Inc.1462 1462 Groverhill Golf & Country Club Inc.1462 La Compagnie d'Approvisionnement 1462 d'Eau Limitée.1462 Les Produits Laitiers Laurentide Li- 1462 mitée.1462 1462 Melbrook Garment Incorporated.1462 1463 Sanguinet Limitée.' 1463 1463 Venus Jewellery Mfg.Ltd.1463 Company Licensed to do Business: 1463 Dan River Mills, Incorporated.1463 Companies Dissolved: 1463 Christie Mining Syndicate Incorporated 1463 1464 Cowansville Realties, Limited.1464 1464 Darwood Mining Company.1464 1498 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 84, N° 28 Goldfinch Mines Limited.1464 Laurentian Investment Company.1464 Paul H.Plamondon Inc.1464 Victory Investments Limited.1465 DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de Des Boules.1465 Hatley-Ouest (Protestante).1465 Hatley-Ouest (Protestante).1467 Lac Lemoine.1466 Laurentia.protestante.1469 Orford.1466 Orford.1466 Pont-Viau.1466 Rapide-des-Chênes.1467 St-Germain-dc-Rimouski.1469 St-Laurent, protestante (Corrections).1468 St-Nazaire-d'Acton.1467 St-Pie.1466 Ville St-Laurent (Protestante).1468 Terres et Forets: Service du Cadastre: St-Antoine-de-Longueuil, paroisse.1470 Travail: Arts graphiques, Saguenay (Prélèvement) .1474 Barbier, coiffeur et coiffeuse, comtés d'Argenteuil, etc.(Modification)- 1471 Construction, Montréal (Modification).1470 Construction, comtés de Terrebonne, etc.(Modification).1471 Construction, Trois-Rivières) Prélèvement) .1472 Meuble, Québec (Prélèvement).1475 Meuble, Québec (Règlements).1470 Examens du Barreau: Arthabaska, pratique du droit.1477 Arthabaska, étude du droit.1477 Bas St-Laurent, pratique du droit.1477 Laurentides: pratique du droit.1476 Richelieu: pratique du droit.1477 Greffes de notaires: Adam, Paul-André.1478 Beaudoin, Charles.1478 Cataphard, Lucien.1478 St-Pierre, Marcel.1478 Lettres patentes: A.Billet Ltée.1444 Ace Holdings Corporation.1445 Alpa Mfg.Co.Ltd.1445 Easy Off Mfg.Co.Ltd.1445 Excelsior Pad Company Ltd.1446 Fournel & Charron Ltée.1446 Laval Industries Ltd.1446 Le Club de Ski Mont Givré Inc.1447 Le Comité protecteur du groupe scout de Loretteville Inc.1447 Les Placements Trudeau Ltée.1447 New Hollywood Furs Inc.1448 Regent Tobacco & Confectionery Corn-, pany Limited.1448 St-Ours Drive Yourself Limited.- 1448 Service des Loisirs de St-Louis-de-Gonzague.1449 Goldfinch Mines Limited.1464 Laurentian Investment Company.1464 Paul H.Plamondon Inc.1464 Victory Investments Limited.1465 DEPARTMENTAL NOTICES: Education: School Municipality of: Des Boules.1465 West Hatley (Protestant).1465 West Hatley (Protestant).1467 Lac Lemoine.1466 Laurentia, protestant.1469 Orford.1466 Orford.1466 Pont-Viau.1466 Rapide-des-Chênes.1467 St-Germain-de-Rimouski.1469 St-Laurent, protestant (Corrections) .1468 St-Nazaire-d'Acton.1467 St-Pie.1466 Town St.Laurent (Protestant).1468 Lands and Forest: Cadastral Branch: St-Antoine-de-Longueuil, parish.1470 Labour: Arts graphiques, Saguenay (Levy).1474 Barber and hairdressing, counties of Argenteuil, etc.(Amendment).1471 Construction, Montreal (Amendment).1470 Construction, counties of Terrebonne, etc.(Amendment).1471 Building, Three Rivers (Levy).1472 Furniture, Quebec (Levy).1475 Furniture, Quebec (By-Laws).1470 Bar Examinations: Arthabaska, practice of law.1477 Arthabaska, study of law.1477 Lower St.Lawrence, practice of law.1477 Laurentides: practice of law.1476 Richelieu: practice of law.1477 Notarial Records: Adam, Paul-André.;.1478 Beaudoin, Charles.1478 Cataphard, Lucien.1478 St-Pierre, Marcel.1478 Letters Patent: A.Billet Ltée.1444 Ace Holdings Corporation.1445 Alpa Mfg.Co.Ltd.1445 Easy Off Mfg.Co.Ltd.1445 Excelsior Pad Company Ltd.1446 Fournel & Charron Ltée.1446 Laval Industries Ltd.1446 Le Club de Ski Mont Givré Inc.1447 Le Comité protecteur du groupe scout' de Loretteville Inc.1447 Les Placements Trudeau Ltée.1447 New Hollywood Furs Inc.1448 Regent Tobacco & Confectionery Company Limited.1448 St-Ours Drive Yourself Limited.- 1448 Service des Loisirs de St-Louis-de-Gonzague.1449 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 7th, 1952, Vol.84, No.28 1499 Transport André Grégoire Limitée .1449 United Customs Brokers Limited.1449 West-End Farm Service Ltd.1450 You Ne Da Bread & Union Bread Company Limited.1450 Lettres patentes supplémentaires: Alpine Resorts Limited.1450 École Supérieur de Commerce de Québec, Inc.1450 La Cie Etchemin Ltée.1451 Le Comité des Chemins d'Hiver de St-Joseph de Kamouraska Inc.1451 Technical Accessories Limited.1451 William Barbara Corporation.1451 Wilmont Realties Limited.1452 Liquidation: \u2014 Avis de: Nadeau & Dumont Enr.1478 Ministère des Finances: Assurances: L'Association de Secours Mutuels des Employés de J.A.Vachon & Fils Limitée et des Produits Diamant Enr.1479 Nominations: Président d'élection.1479 Présidents d'élection.1479 Sièges sociaux: Association des Chirurgiens de la Province de Québec \u2014 Association of Surgeons of the Province of Quebec.1482 Explosives Sales Ltd.1481 Masson & Sons, Limited.1482 Ste-Sophie Lumber Co.Ltd.1482 Soumissions: Asbestos, ville de.1488 Beaconsfield, ville de.1482 \u2022 Cap-Chat, village.1485 Iles-Perrot-Nord, Commission scolaire.1487 Rivière-du-Moulin, village de.1483 St-Laurent, commission scolaire.1486 Waterloo, ville de.1484 Vente par licitation: Céré et al vs Céré étal.1489 VENTES PAR SHÉRIFS: Bedford: Crawford vs Brock et al.1490 Loi fédérale sur les Droits successoraux vsMintz.1490 Pigeon vs Surprenant.1491 Hull: Lauzon vs Héritiers de R.Marengère.1491 Montréal: Gadbois et al vs Bernier.1492 Perras vs Roy.#.1492 Metropolitan Coal Import Inc.vs Davis etvir.1493 St-Dizier vs Des Indes.1292 Transport André Grégoire Limitée .1449 United Customs Brokers Limited.1449 West-End Farm Service Ltd.1450 You Ne Da Bread & Union Bread Company Limited.1450 Supplementary Letters Patent: Alpine Resorts Limited.1450 École Supérieure de Commerce de Québec, Inc.1450 La Cie Etchemin Ltée.1451 Le Comité des Chemins d'Hiver de St-Joseph de Kamouraska Inc.1451 Technical Accessories Limited.1451 William Barbara Corporation.1451 Wilmont Realties Limited.1452 Winding up Notices: Nadeau & Dumont Enr.1478 Department of Finance: Insurances: L'Association de Secours Mutuels des Employés de J.A.Vachon & Fils Limitée et des Produits Diamant Enr.1479 Appointments: Returning Officer.1479 Returning Officers.1479 Head Offices: Association of Surgeons of the Province of Quebec \u2014 Association des Chirurgiens de la Province de Québec.1482 Explosives Sales Ltd.1481 Masson & Sons, Limited.1482 Ste-Sophie Lumber Co.Ltd.1482 Tenders: Asbestos, town of.1488 Beaconsfield, town of.1482 Cap-Chat, village.1487 Iles-Perrot-Nord, School Commission.1485 Rivière-du-Moulin, village of.1483 St-Laurent, School Commission.1486 Waterloo, town of.1484 Sale by Li citation: Céré et al vs Céré et al.1489 SHERD7FS' SALES: Bedford: Crawford vs Brock et al.1490 Loi fédérale sur les Droits successoraux vs Mintz.1490 Pigeon vs Surprenant.1491 Hull: Lauzon vs Heirs of R.Marengère.1491 Montreal: Gadbois et al vs Bernier.1492 Perras vs Roy.1492 Metropolitan Coal Import Inc.vs Davis etvir.1493 St-Dizier vs Des Indes.1492 1500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 juin 1952, Tome 94, N° 23 Québec: Fortin vs Larouche.1495 Le Comptoir de Crédit Ltée vs Auger.1495 Richelieu: Racine vs Charbonneau.1495 Saint-Hyacinthe : Corporation municipale du village de Ste-Hélène vs Lafontaine.1496 32708-o Quebec: Fortin vs Larouche.1495 Le Comptoir de Crédit Ltée vs Auger.1495 Richelieu: Racine vs Charbonneau.1495 Saint Hyacinthe: Municipal Corporation of the village of Ste.Hélène, vs Lafontaine.1496 32708-o Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.