Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 juin 1952, samedi 28 (no 26)
[" Tome 84, N° 26 1631 Vol.84, No.26 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 28 juin 1952 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1952.Québec, le 16 juin 1952.L'Imprimeur de la Reine.32799-25-lO-o RÊDEMPTI PARADIS.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 28st, 1952 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1952.Quebec, this 16th of June 1952.RÊDEMPTI PARADIS, 32799-25-10-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1632 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazelle officielle de Québec est publiée le samedi mutin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou'pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.fl° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agule, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes île noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième a celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.31753\u2014 1-52 Lettres patentes Academy Sportswear Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morissct, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douzième jour de mai 1952, constituant en corporation: Max Liverman.Julius Briskin, Leonard Liverman, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank j or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties arc requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.* Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: \u2022 The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governcment House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u2014 1-52 Letters Patent Academy Sportswear Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q., 1941, bearing date the twelth day of May 1952, incorporating: Max Liverman, Julius Briskin, Leonard Liverman, Advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1962, Vol.84, No.26 1633 Manufacturer et faire le commerce d'articles vestimentaires et vêtements de sport, sous le nom de \"Academy Sportswear Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté au bureau du Procureur général, le douzième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Associated Lumber & Pulp Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour de mai 1952, constituant en corporation: Hyman Katz, marchand, Lazarus L.Tinkoff, Frank F.Hubschcr, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, commercer et négocier du bois de pulpe et bois de construction de toutes sortes, sous le nom de \"Associated Lximber & Pulp Corporation\", avec un capital de $100,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Bégin et Pépin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneuf de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du, dix mai 1952, constituant en corporation: Madeleine Vallée Pépin, marchande, épouse séparée de biens de Leopold Pépin, de St-Lazare, district judiciaire de Montmagny, Charles-Noël Bégin, imprimeur, Raynold Bélanger avocat, de Lévis, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de magasin général, sous le nom de \"Bégin et Pépin Ltée\", avec un capital de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lazare, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général le dix mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Brouillard, Automobile Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf mai 1952, constituant en corporation: Paul-Emile Brouillard, Jean-Paul Bernier, garagistes, Doris Robert, avocat, de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Exercer le commerce des automobiles, réfrigérateurs et de leurs accessoires, sous le nom de \"Brouillard Automobile, Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.To manufacture and deal in wearing apparel, and sportswear, under the name of \"Academy Sportswear Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of $100 each and 200 common shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attornev General, this twelth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Associated Lumber & Pulp Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1952, incorporating: Hyman Katz, Merchant, Lazarus L.Tinkofl\", Frank F.Hubschcr, Advocates, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture, trade and deal in timber and lumber of all kinds, under the name of \"Associated Lumber & Pulp Corporation\", with a capital stock of 8100,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of 820 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Bégin et Pépin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of May, 1952, incorporating: Madeleine Vallée Pépin, merchant, wife separate as to property of Leopold Pépin, of St-Lazare, judicial district of Montmagny, Charles Noël Begin, printer, Raynold Bélanger, advocate, of Levis, Judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on a general store business, under the name of \"Bégin et Pépin Ltée\", with a capital stock of S50,000, divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at St-Lazare, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Brouillard, Automobile Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor fo the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1952, incorporating: Paul-Emile Brouillard, Jean-Paul Bernier, garage-keepers, Doris Robert, advocate of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To deal in automobiles, refrigerators and in their accessories, under the name of \"Brouillard Automobile, Limitée\", with a capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each. 1634 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Central Lumber Products Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du sept mai 1952, constituant en corporation: Howard John Kirby, entrepreneur, de Montréal, Alphonse Desjardins, industriel, de Ville St-Laurent, Henri Masson Loranger, avocat, de Westmount, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits en bois, métal ou plastique, effets mobiliers, meubles, garnitures et accessoires, sous le nom de \"Central Lumber Products Limited\", avec un capital de §15,000, divisé en 900 actions privilégiées de 810 chacune et 600 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 371 Boulevard Décarie, Ville St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Continental Steel Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1952, constituant en corporation: Ernest Lafontaine, avocat, George Albert Wanless, comptable, Roberte Smith, fille majeure, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises entièrement ou partiellement faites de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre, et leurs sous-produits, sous le nom de \"Continental Steel Company Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DESILETS.Crémerie Drummondville, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorze mai 1952, constituant en corporation: Gonzague Grégoire, industriel, Gaston Grégoire, Renaud Grégoire, gérants d'usine, tous de Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General this ninth day of Mav, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Central Lumber Products Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province.of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May 1952, incorporating: Howard John Kirby, Contractor, of Montreal, Alphonse Desjardins, Industrialist, of Ville St-Laurent, Henri Masson Loranger, Advocate, of Westmount, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of woods, metal or plastic products, movables, furniture, trimmings and accessories, under the name of \"Central Lumber Products Limited\", with a capital stock of $15,000, divided into 900 preferred shares of $10 each and 600 common shares of $10 each.The head office of the Company will be at 371 Décarie Boulevard, Ville St.Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Continental Steel Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May 1952, incorporating: Ernest Lafontaine, Advocate, George Albert Wanless, Accountant, Robcrte Smith, Spinster, Secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles and merchandise made, in whole or in part of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by products of same, under the name of \"Continental Steel Company Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of Mav 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Crémerie Drummondville, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of May, 1952, incorporating: Gonzague Grégoire, industrialist, Gaston Grégoire, Renaud Grégoire, plant managers, all of Drummondville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1635 Faire le commerce du lait et de la crème et de leurs produits ou sous-produits sous le nom de \"Crémerie Drummondville, Limitée\", avec un capital de S 100,000, divisé en 1,000 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 193 rue Lindsay, Drummondville, district judiciaire d'Ar-thabaska.Daté du bureau du Procureur général le quatorze mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.David W.Armstrong & Son Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dixième jour de mai 1952, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, avocats, Freda Pomcrance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits de fer et d'acier, machines, machineries et exercer le commerce général d'entreposage, sous le nom de \"David W.Armstrong & Son Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Dominion Commodity Co., Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1952, constituant en corporation: Jefim Lifszyc, Frank E.Berry, Ilya Kabay, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour Ids objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises sèches, textiles, accessoires de maison, quincaillerie, fournitures de maison et vêtements, sous le nom de \"Dominion Commodity Co., Ltd.\" avec un capital ce 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Eastern Traders Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trentième jour de mai 1952, constituant en corporation: Nathan Levitsky, Solomon Weber, avocats, Hattie Herman, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: To deal in milk and cream, and in the products and by-products thereof, under the name of \"Crémerie Drummondville, Limitée\", with a capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 193 Lindsay Street, Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.David W.Armstrong & Son Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of May 1952, incorporating: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, Advocates, Freda Pomerance, Secretary, Spinster, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes; To deal in iron and steel products, machines, machinery; carry on the business of general warehousing, under the name of \"David W.Armstrong & Son Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Dominion Commodity Co., Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May 1952, incorporating: Jefim Lifszyc, Frank E.Berry, Ilya Kabay, Merchants, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, textiles, household appliances, hardware, household furnishings, wearing apparel, under the name of \"Dominion Commodity Co., Ltd.\", with a capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May 1952.L.DÉSILETS, 32852-0 Deputy Attorney General.Eastern Traders Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of May 1952, incorporating: \"Nathan Levitsky, Solomon Weber, Advocates, Hattie Herman, Stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: 1636 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits en cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et leurs sous-produits, sous le nom de \"Eastern Traders Ltd.\" avec un capital de S40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS, Fly-Master Corporation of Canada Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.A.fred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941.des lettres patentes en date du vingt-sept mai 1952, constituant en corporation: Antoine Desmarais, gérant, Maurice Trudeau, C.R., avocat, tous deux d'Outremont, François Morel, avocat, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturier et faire le commerce de toutes sortes de dispositifs et produits chimiques servant à la destruction des insectes, sous le nom de \"Fly-Master Corporation of Canada\", avec un capital de SI 10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune, et 1,000 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Gagnon Frères Meubles (Port-Alfred) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente avril 1952, constituant en corporation: Raymond Gagnon, commerçant, Dollard Blackburn, commis, Léon-Georges Gagnon, comptahlc-agréé, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'ameublements et toutes garnitures de maison et de ferme, accessoires électriques, sous le nom de \"Gagnon Frères Meubles (Port-Alfred) Ltée\", avec un capital de S20.000, divisé en 2,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Port-Alfred, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.To manufacture and deal in all kinds of products of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products under the name of \"Eastern Traders Ltd.\", with a capital stock of S40,000, divided into 20,000 common shares of SI each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-o Deputy Attorney General.Fly-Master Corporation of Canada Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-seventh day of May 1952, incorporating: Antoine Desmarais, Manager, Maurice Trudeau, Q.C., Advocate, both of Outremont, François Morel, Advocate.of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of insects control devices and chemicals, under the name of \"Flv-Master Corporation of Canada\", with a capital stock of Si 10,000, divided into 1,000 common shares of S10 each and 1,000 preferred shares of S100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-seventh day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Gagnon Frères Meubles (Port-Alfred) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1952.incorporating: Raymond Gagnon, trader, Dollard Blackburn, clerk, Léon Georges Gagnon, chartered accountant, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture and all household furnishings, farm implements, electric accessories, under the name of \"Gagnon Frères Meubles (Port-Alfred) Ltée\", with a capital stock of S20.000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Port-Alfred, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Giant Chibougamau Mines Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.Alfred Iorisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dixième jour de mai 1952, constituant en corporation: Henri Crépeau.avocat, Conseil en Giant Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of May 1952, incorporating: Henri Crépeau, Advocate, Queen's QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol 84, No.26 mi Loi de la Heine, Françoise Gagnon, Yvette Picard, toutes deux secrétaires, filles majeures, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais, sous le nom de \"Giant Chibougamau Mines Ltd.\", avec un capital de $3,000,000, divisé en $3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à 132 ouest, rue St-Jacqucs, chambre 326, en les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Glendale Cleaners and Dyers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mai 1952, constituant en corporation: Marcel Canal, industriel, Ghislaine Gagné, Jeanne Salaun, toutes deux secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de teinturier et nettoyeur, sous le nom de \"Glendale Cleaners and Dyers Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 1,000 actions communes de SI chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lon-gueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-o L.DÉSILETS.Grayhouse Realties \"Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorzième jour de mai 1952, constituant en corporation: Sol Sidney Fels, de Westmount, David L.Cahana, de Montréal, avocats, Audrey M.Sutherland, secrétaire, épouse séparée de biens de John M.A.Sutherland, d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Grayhouse Realties Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 390 actions privilégiées de $100 chacune et 10 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Hamilton Nursing Home Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mai 1952, constituant en corporation: Counsel, Françoise Gagnon, Yvette Picard, both Secretaries, Spinsters, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Giant Chibougamau Mines Ltd\" (No Personal Liability), with a capital stock of $3,000,000, divided into 3,000,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will be at 132 St.James St.West room 326, in the City and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Glendale Cleaners and Dyers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of ±he Province of Quebec, bearing date the third day of May, 1952, incorporating: Marcel Canal, industrialist, Ghislaine Gagné, Jeanne Salaun, both secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dyer and cleaner, under the name of \"Glendale Cleaners and Dyers Ltd.\", with a capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $1 each, and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Grayhouse Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of May 1952, incorporating: Sol Sidney Fels, of Westmount, David L.Cahana, of Montreal, Advocates, Audrey M.Sutherland, Secretary, Wife separate as to property of John M.A.Sutherland, of Outremont, Judicial District of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Grayhouse Realties Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 390 preferred shares of $100 each and 10 common shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May 1952._ L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Hamilton Nursing Home Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act,, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of May 1952, incorporating: Lester Eric HamW 1638 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tomé 84, N* 26 Lester Eric Hamilton, vendeur, Dame Florence Bigelow Hamilton, épouse séparée de biens de Lester Eric Hamilton, ménagère, Roy John Bigelow, entrepreneur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une maison de repos et de convalescence privée, sous le nom de \"Hamilton Nursing Home Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au Village de Côte St-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Harnish Fisheries Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du troisième jour de mai 1952, constituant en corporation: Lindsay Buck, Forbes Buck, tous deux gérants, Georgette Boudreau, fille majeure, tous de Grindstone, Iles de la Madeleine, district judiciaire de Gaspé, pour les objets suivants: Exercer le commerce de pêcheries, sous le nom de \"Harnish Fisheries Limited\", avec un capital de $50,000, divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grindstone, Iles de la Madeleine, district judiciaire de Gaspé.Daté du bureau du Procureur général, ce troisième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Hudson Planned Homes Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-septième jour de mai 1952 constituant en corporation: Clifford George Meck, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, Kenneth Simpson Howard, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Hudson planned Homes Limited\", avec un capital de 85,000, divisé en 5,000 actions de $1 chacune.Le .siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-septième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.ton, Salesman, Dame Florence Bigelow Hamilton, Wife separate as to property of Lester Eric Hamilton, Housewife, Roy John Bigelow, Contractor, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To operate a private nursing and convalescent home, under the name of \"Hamilton Nursing Home Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at the Village of Cote St.Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney'General, this third day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-o Deputy Attorney General.Harnish Fisheries Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of May 1952, incoqjorating: Lindsay Buck, Forbes Buck, both Managers, Georgette Boudreau, Spinster, all of Grindstone, Magdalen Islands, Judicial District of Gaspé, for the following purposes: To carry on a fishing business, under the name of \"Harnish Fisheries Limited\", with a capital stock of 850,0000, divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Grindstone, Magdalen Islands, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May 1952.- L.DÉSUETS, 32853-0 L.DÉSILETS.Hudson Planned Homes Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-seventh day of May 1952, incorporating: Clifford George Meek, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, bookkeepers, Cecil Bruce Cooke, Secretary, Kenneth Simpson Howard, Advocate, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general builders and contractors, under the name of \"Hudson Planned Homes Limited\", with a capital stock of 85,000, divided into 5,000 shares of $1 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of Mav 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.J.E.Hanger of Montreal Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le.Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huit avril 1952, constituant en croporation: J.E.Hanger of Montreal Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eight day of April 1952, incorporating: Samuel E. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1639 Samuel E.Schwisberg, conseil en loi de la Reine, Cyril E.Schwisberg, avocat, d'Outremont, Sonya Schneyer, fille majeure, secrétaire, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands d'appareils et instruments d'orthopédie, de prosthétique et de chirurgie, sous le nom de \"J.E.Hanger of Montreal Ltd.\", avec un capital de 810,000, divisé en 8,000 actions ordinaires de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Kennebec Lumber Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt mai 1952, constituant en corporation: Georges-Henri Boulet, de Sillery, Edgr-Ludger Boulet, de Québec, tous deux comptables agréés, Françoise Bouchard, fille majeure, de Charles-bourg, District judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de bois, de tous les sous-produits du bois et de matériaux de construction, sous le nom de \"Kennebec Lumber Inc.\", avec un capital de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Schwisberg, Queen's Counsel, Cyril E.Schwisberg, Advocate, of Outremont, Sonya Schneyer, Spinster, Secretary, of Montreal, Judicial District .of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers, and dealers in orthopoedic, prosthetic and surgical appliances and supplies, under the name of \"J.E.Hanger of Montreal Ltd.\", with a capital stock of 810,000, divided into 8,000 common shares of 81 each and 2,000 preferred shares of SI each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eight day of April 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 .Deputy Attorney Generzl.Kennebec Lumber Inc.Notice is hereby given' that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of May, 1952, incorporating: Georges Henri Boulet, of Sillery, Edgar Ludger Boulet, of Quebec, both chartered accountants, Françoise Bouchard, spinster, of Charlcsbourg, judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the lumber business, deal in ali by-products of wood, and in building requisites, under the name of \"Kennebec Lumber Inc.\", with a capital stock of 810,000, divided into 100 common shares, of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.La Chambre de Commerce des Jeunes de Montmorency Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mai 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel DeBlois, Philippe Vaillancourt, comptables, Fernand Houdc, Weiley Vézina, contremaîtres, Roger Bouchard, Alphonse Daigle, commis de bureau, Ludger Sa-vard, magasinier, Raymond Gingras, assistant-contremaître, Albert Robitaille, commis, Maurice Lavoie, taxi, tous de St-Grégoire, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir dans l'intérêt et pour le bénéfice des jeunes gens du district de Montmorency, sous le nom de \"La Chambre de Commerce des Jeunes de Montmorency\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la compagnie sera à Montmorency, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-q L.DÉSILETS.La Chambre de Commerce des Jeunes de Montmorency Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of May, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Marcel DeBlois, Philippe Vaillancourt, accountants, Fernand Houdc, Weiley Vézina, foremen, Roger Bouchard, Alphonse Daigle, office clerks, Ludger Savard, storeman, Raymond Gingras, assistant foreman, Albert Robitaille, clerk, Maurice Lavoie taxi driver, all of St-Grégoire, judicial district of Quebec, for the following purposes: To act in the interest and for the benefit of the young people of the district of Montmorency, under the name of \"La Chambre de Commerce des Jeunes de Montmorency\".The amount to which the immovable property which the corporation mav hold is to be limited, is 825,000.The head office of the company will be at Montmorency, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attornev General, this third day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.\\ \\ La Cie d'Excavations Bonneau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du treize mai 1952, constituant en corporation: William Grant, avocat, de Montréal, Kathleen Mackenzie, Jeannette )3issonnette, secrétaires, d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer toutes les opérations relatives aux excavations, creusage et dragage, sous le nom de \"La Cie d'Excavations Bonneau Ltée\", avec un capital de §100,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et 800 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mackay-villc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le treize mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.La Compagnie Thuot & Goyctte Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuf mai 1952, constituant en corporation: Emma Goyctte, veuve d'Alphonse Nadeau, Laura Thuot, veuve d'Ernest Thuot, Alice Thuot, toutes trois ménagères, Lucien Thuot, gérant, Roland Thuot, nettoyeur, tous d'Iber-ville, Henri Thuot, Guy Thuot, journaliers, Z.Oscar Thuot, gérant, tous trois de St-Jean, district judiciaire d'Ibcrville, Jean-Charles Thuot, journalier, de Farnham, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: La capture et la vente des poissons et toutes opérations commerciales s'y rattachant, sous le nom de \"La Compagnie Thuot & Goyctte Limitée ', avec un capital de S7,000, divisé en 70 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Iberville, district judiciaire d'Ibcrville.Daté du bureau du Procureur général le neuf mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.La Corporation de L'Hôpital St-AIexandre des Escoumins Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941.des lettres patentes en date du quinze mai 1952, constituant en corporation sans capital-actions: L'abbé Edilbcrt Lcvesquc, prêtre, curé, Charles-Walter Bélanger, marchand, J.-R.Pelchat, marchand, Léon Tremblay, mesureur, Rolland Boulianne, gérant de banque, Antoine Gagnon, médecin, tous de Les Escoumins, L'abbé V.Giroux, prêtre, curé, de Sault-au-Mouton, Jean-Charles Gagnon, aviculteur, de Bergeronnes, district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Etablir et administrer un hôpital, sous le nom de \"La Corporation de l'Hôpital St-Alexandre des Escoumins.La Cie d'Excavations Bonneau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of May, 1952, incorporating: William Grant, advocate, of Montreal, Kathleen Mackenzie, Jeannette Bissonuette, secretaries, of Outremont, judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in all operations connected with excavations, digging and dredging, under the name of \"La Cie d'Excavations Bonneau Ltée\", with a capital stock of S 100,000, divided into 20,000 common shares of SI each and 800 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Mackayville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of Mnv, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.La Compagnie Thuot & Goyctte Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2, chapter 276,R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of May, 1952, incorporating: Emma Goyette, widow of Alphonse Nadeau, Laura Thuot, widow of Ernest Thuot, Alice Thuot, all three housewives, Lucien Thuot, manager, Roland Thuot, cleaner, all of Iberville, Hcnvi Thuot, Guy Thuot, laborers, Z.Oscar Thuot, manager, all three of St-John's judicial, district of Iberville, Jean-Charles Thuot, laborer, of Farnham, judicial district of Bedford, for the following purposes: The catchiug and sale of fish and all commercial operations pertaining thereto, under the name of \"La Compagnie Thuot & Goyette Limitée\", with a capital stock of 87,000, divided into 70 shares of S100 each.The head office of the company will be at Iberville, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.La Corporation de L'Hôpital St-Alexandre des Escoumins Notice is hereby given that tinder Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: l'abbé Edilbcrt Lcvesquc, parish priest, Charles-Walter Bélanger, merchant, J.-R.Pelchat, merchant, Léon Tremblay, scaler, Rolland Boulianne, bank manager, Antoine Gagnon, physician, all of Les Escoumins, l'abbé V.Giroux, parish priest of Sault-au-Mouton, Jean-Charles Gagnon, poultryman, of Bergeronnes, judicial district of Sagucnay, for the following purposes; To establish and manage a hospital under the name of \"La Corporation de l'Hôpital St-Alexandre des Escoumins.\".1640 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1962, Vol.84, No.26 1641 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $200,000.Le siège social de la compagnie sera à Les Escoumins, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général le quinze mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILETS.La Ligue des Propriétaires de la Pointe-aux-Trembles Property Owner's League of la Pointe-aux-Trembles Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorze mai 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Romuald Tassé,gérant des ventes, Frank Skelton, surveillant de sécurité, (Safety Supervisor), Aristide Dubreuil, vérificateur, Y van Layer, commis, Olalis Latendressc, marchand, Joseph Adélard Lapointe, comptable tous de Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Défendre les intérêts des propriétaires auprès des autorités municipales, scolaires, provinciales ou fédérales, sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires de la Pointe-aux-Trembles\" \"Property Owner's League of la Pointe-aux-Trembles\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Pointeaux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Le Club des Lions de Québec, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2.chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit mai 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Romulus Drolet, C.L.U.assureur-vie, Ernest Maheux, comptable, Aimé Déry, industriel, Percy Auger, comptable agréé, Jean Bérubé, avocat, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Former un corps d'hommes représentant les intérêts commerciaux et professionnels de la ville de Québec et Sillcry.sous le nom de \"Le Club des Lions de Québec, Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de dix mille dollars.Le siège social de la Corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le huit mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILETS.The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $200,000.The head office of the company will be at Les Escoumins, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.La Ligue des Propriétaires de la Pointe-aux-Trembles Property Owner's League of la Pointe-aux-Trembles Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourteenth day of May, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Romual Tassé, sales manager, Frank Skelton, safety supervisor, Aristide Dubreuil, auditor, Yvan Layer, clerk, Olalis Latendressc, merchant, Joseph Adélard Lapointe, accountant, all of Pointe-aix-Trembles, judicial district of Montreal, for the following purposes: To defend the interests of property owners before the municipal, school, provincial or federal authorities, under the name of \"La Ligue des Propriétaires de la Pointe-aux-Trembles\"\u2014\"Property Owner's League of la Pointeaux-Trembles\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited is $25,000.The head office of the corporation will be at Pointe-aux-Trembles.judicial district of Montreal.Dated at the office of.the Attorney General, this fourteenth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Le Club des Lions de Québec, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of May, 1952, to incorporate as a corporation without share capital: Romulus Drolet, C.L.U., life insurance agent, Ernest Maheux, accountant, Aimé Déry, industrialist, Percy Auger, chartered accountant, Jean Bérubé, advocate, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To organize a body of men representing the commercial and professional interests of the City of Quebec and Sillery, under the name of \"Le Club des Lions de Québec, Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is ten thousand dollars.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General. 1642 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 Les Immeubles Bernicr Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinze mai 1952, constituant en corporation: (ïérard Bernicr, négociant, de Jonquière, Ray-mond-M.Pelletier, commis-voyageur, Pauline Lagueux, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Raymond-M.Pelletier, et dliment autorisée par ce dernier, de Kéno-gami, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire le commerce général de biens immobiliers et les opérations générales d'agents d'immeubles et d'entrepreneurs, constructeurs, sous le nom de \"Les Immeubles Bernicr Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 278 rue St-Pierre, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Mansions Garage (Sales and Service) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix mai 1952, constituant en corporation: Armand Michaud, commerçant, Jeanne d'Arc Michaud, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Armand Michaud, tous deux de Montréal, Yves Thuot, commerçant, de Ste-Rose, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules moteurs et agir comme garagiste, sous le nom de \"Mansions Garage (Sales and Service) Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Les Immeubles Bernicr Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May, 1952, incorporating: Gérard Bernicr, merchant of Jonquière, Raymond M.Pelletier, travelling salesman, Pauline Lagueux, housewife, wife separate as to property by marriage contract of the said Raymond M.Pelletier, and duly authorized by the latter, of Kcnogami, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal generally in real estate and carry on the general transactions ' of real estate agents and contractors, builders, under the name of \"Les Immeubles Bernicr Limitée'\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 278 St-Peter Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of Mav, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Mansions Garage (Sales and Service) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of May, 1952, incorporating: Armand Michaud, dealer, Jeanne d'Arc Michaud, housewife separate as to property by marriage contract, of the said Armand Michaud, both of Montreal, Yves Thuot, dealer, of Ste-Rosc, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in motor vehicles and act as garage-keeper, under the name of \"Mansions Garage (Sales and Service) Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this tenth day of May, 1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General.Material Industries, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mai 1952, constituant en corporation: Samuel E.Schwisberg, conseil en loi de la Reine, Cyril E.Schwisberg, avocat, tous deux d'Outre-mont, Sonya Schneyer, fille majeure, secrétaire, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce comme chimistes consultants et celui qui consiste à manufacturer, acheter et vendre toutes 'sortes et genres de produits chimiques et ses composés, sous le nom de \"Material Insustries, Ltd.\", avec un capital de $10,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 5,000 actions privilégiées de $1 chacune.Material Industries, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1 been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of May 1952, incorporating: Samuel E.Schwisberg, Queen's Counsel, Cyril É.Schwisberg, Advocate, both of Outremont, Sonya Schneyer, Spinster, Secretary, of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of consulting chemists and the manufacturing, buying and selling of all manners and types of chemicals and compounds thereof, under the name of \"Material Industries, Ltd.\", with a capital stock of $10,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 5,000 preferred shares of $1 each. I QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1643 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de'Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.M on t m a r t r e^Ca ii ad i en Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix mai 1952, constituant en corporation sans capital-actions: Révérends Pères André Godbout, supérieur, Maurice Gagnon, sous-prieur, Jean-Marie Rioux, économe, Alexandre Beaudet, Daniel Bergeron, Xavier Vandcrmeerschen, professeurs, tous Augustin de L'Assomption, de Sillery, district judiciaire de Québec pour les objets suivants: Propager la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus par tous les moyens, sous le nom de \"Montmartre Canadien.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à 1679 Chemin Saint-Louis, Sillery, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.Montreal Appliance Service Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuf mai 1952, constituant en corporation: Georges-Emile Roy, industriel, Emile Brière, commerçant, Guy Racicot, voyageur de commerce, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'effets mobiliers, électriques ou frigorifiques, sous le nom de \"Montreal Appliance Service Corporation Ltd\", avec un capital de §50,000, divisé en 2,000 actions de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 762 Beaubien Est, Chambre 2, dans les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.Northfield Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du treizième jour de mai 1952, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry Lyon Aro-novitch, avocats, Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, en les cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Montmartre Canadien Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of May, 1952, to incorporate as a corporation -without shaie capital: The Reverend Fathers André Godbout, superior, Maurice Gagnon, sub-prior, Jean Marie Rioux, économe, Alexandre Beaudet, Daniel Bergeron, Xavier Vandermeers-chen, professors, all members of \"Augustin de L'Assomption\", of Sillery, judicial district of Quebec, for the following purposes: To spread devotion to the Sacred Heart of Jesus by every means, under the name of \"Montmartre Canadien\".The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.\u2022 The head office of the corporation will be at 1679 Saint Louis Road, Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Montreal Appliance Service Corporation Ltd.\"* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of May, 1952, inconporating: Georges Emile Roy, industrialist, Emile Brière, merchand, Guy Racicot, commercial traveller, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in movable effects, whether electric or refrigerating, under the name of \"Montreal Appliance Service Corporation Ltd.\", with a capital stock of $50,000, divided into 2,000 shares of $25 each.The head office of the company will be at 762 Beaubien East, Room 2, in the city and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General, Northfield Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of May 1952, incorporating: Samuel Chait, Harry Lyon Aronovitch, Advocates, Freda Pomerance, Secretary, fille majeure, in the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes : 1644 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Northfield Holdings Inc.\", avec un capital de $100,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnies sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Northland Cleats & Lumber Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douze mai 1952, constituant en corporation : Marcel Labelle, entrepreneur, de Val d'Or, Mauric Labelle, marchand, de Vassan, tous deux du district judiciaire 'dAbitibi, Albert Belzil, marchand de bois, de Trois-Pistolcs, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bois, de ses produits et sous-produits, sous le nom de \"Northland Cleats & Lumber Co.Ltd.\", avec un capital de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le douze mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILETS.I _.Olivier Auto Val d'Or Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douze mai 1952, constituant en corporation: Wilfrid Olivier, garagiste, Florian Vachon, comptable, de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, Paul Caouette, gérant de Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux, exploiter des garages, sous le nom de \"Olivier Auto Val d'Or Ltée\", avec un capital de $75,000, divisé en 7,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le douxe mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILETS.Opemisca Explorers Limited (Libre de responsabilité' personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions -de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deuxième jour de mai 1952, constituant en corporation: John Austin Murphy, C.R., avocat, Robert H.Waddell, comptable, Lottie Pachal, Eleanor Hart, Mildred Murphy, dactylos, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Northfield Holdings Inc.\", with a capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $100 each and 900 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-o Deputy Attorney General.Northland Cleats & Lumber Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, hearing date the twelfth day of May, 1952, incorporating: Marcel Labelle, contractor, of Val d'Or, Maurice Labelle, mar-chant, of Vassan, both of the judicial district of Abitibi, Albert Belzil, lumber merchant, of Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska, for the following pruposcs: To carry on the lumber business, deal in wood-products and by-products, under the name of \"Northland Cleats & Lumber Co.Ltd.\", with a capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Val d'Or judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1952.L.' DÉSILETS, 32853 Peputy Attorney General.Olivier Auto Val d'Or Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of May, 1952, incorporating: Wilfrid Olivier, garage-keeper, Florian Vachon, accountant, of Val d'Or, judicial district of Abitibi, Paul Caouette, manager, of Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda, for the following purposes : To act as general contractors, operate garages, under the name of \"Olivier Auto Val d'Or Ltée\", with a capital stock of 875,000, divided into 7,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Opemisca Explorers Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May 1952, incorporating: John Austin Murphy, Q.C., Barrister, Robert H.Waddell, Accountant, Lottie Pachal, Eleanor Hart, Mildred Murphy, Typists, Spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1962, Vol.84, No.26 1645 Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais, sous le nom de \"Opemisca Explorers Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de 84,000,000, divisé en 4,000,00 d'actions de SI chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera àMont-réal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.P.A.Daunccy Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des companies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du huitième jour de mai 1952, constituant en corporation: Harry Edward Grundy, Conseil en Loi de la Reine, Charles Alexander White, tous deux avocats, Roger Roy, comptable agréé, de Sherbrooke, district judiciaire de St-Fran-çois, pour les objets suivants: Manufacturer l'acier, le fer et autre métaux, sous le nom de \"P.A.Dauncey Limited\", avec un capital de 850,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Paul Desormeau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trois mai 1952, constituant en corporation: Paul Désormeau, entrepreneur général, Aline Ouellette, épouse contractuellement séparée de biens dudit Paul Désormeau, Rodrigue Beau-champ, contremaître, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de construction, sous le nom de \"Paul Désormeau Limitée\", avec un capital de S49.000, divisé en 49,000 actions ordinaires de Si chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trois mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.P.Hamelin Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois mai 1952, constituant en corporation: Philias Hamelin, Oscar Hamelin, maîtres plâtriers et contracteurs généraux, Emile Hamelin, Prospect and explore for mines and minerais, under the name of \"Opemisca Explorers Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4,000,000, divided into 4,000,000 shares of $1 each.The shareholders of the Company shall incur no personal liability in excess of the price paid or agreed to be paid to the Company for its shares.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-o Deputy Attorney General.P.A.Dauncey Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of May 1952, incorporating: Harry Edward Grundy, Queen's Counsel, Charles Alexander White, both Advocates, Roger Roy, Chartered Accountant, of Sherbrooke, Judicial District of St.Francis, for the following purposes: To manufacture steel, iron and other metals, under the name of \"P.A.Dauncey Limited\", with a capital stock of $50,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the Company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General this eighth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Paul Desormeau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1951, bearing date the third day of May, 1952, incorporating: Paul Désormeau, general contractor, Aline Ouellette, wife separate as to property by marriage contract, of said Paul Désormeau, Rodrigue Beauchamp, foreman, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a construction company, under the name of \"Paul Désormeau, Limitée\", with a capital stock of $49,000, divided into 49,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal,, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.P.Hamelin Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of May, 1952, incorporating: Philias Hamelin, Oscar Hamelin, master-plasterers and general contractors, Emile Hamelin, master-plasterer, 1646 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N° 26 maître plâtrier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations de contracteurs et constructeurs, sous le nom de \"P.Hamelin Limitée\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Powers School (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huit mai 1952, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, Alexander Gordon Yeoman, commis en loi, Cecil Bruce Cooke, John Lawrence McCrory, sténographes, Charles Eric Humphrey, teneur de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir et exploiter une ou des écoles pour l'entraînement général des étudiants, sous le nom de \"Powers School (Canada) Ltd.\", avec un capital de $50,000, divisé en 500 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Promotion & Placements Cie Lté*e Promotion & Investments Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la piovince de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-trois mai 1952, constituant en corporation: Roger Desmarais, gérant, Charles-Edouard Bertrand, avocat, tous deux de Montréal, Guy Girard, notaire d'Outremont, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de promotion et de placements, sous le nom de \"Promotion & Placements Cie Ltée\"\u2014\"Promotion & Investments Co.Ltd.\", avec un capital de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of contractors and builders under the name of \"P.Hamelin Limitée\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Powers School (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eighth day of May 1952, incorporating: Ernest William Mockridgc, Manager, Alexander Gordon Yeoman, Law Clerk, Cecil Bruce Cooke, John Lawrence McCrory, Stenographers, Charles Eric Humphrey, Bookkeeper, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To establish and operate a school or schools for the general training of students, under the name of \"Powers School (Canada) Ltd.\", with a capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.Promotion & Placements Cie Lte*e Promotion & Investments Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of May, 1952, incorporating: Roger Desmarias, manager, Charles-Edouard Bertrand, advocate, both of Montreal, Guy Girard, notary, of Outremont, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a promotion and investment company under the name of \"Promotion & Investments Cie Ltée\"\u2014\"Promotion & Investments Co.Ltd.\", with a capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Quebec Northwest Products Inc.Quebec Northwest Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec; il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douze mai 1952, constituant en corporation: J.-Ernest Veilleux, marchand, Gertrude Bédard, Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, lettres patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of May, 1952, incorporating: J.-Ernest Veilleux, merchant, Gertrude Bédard, wife separate as to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1647 épouse contractuellement séparée de biens de J.-Ernest Vcilleux, et de ce dernier dflment autorisée, J.-Gérard Aubé, gérant, tous de La Sarre, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce des produits forestires et les produits agricoles, sous le nom de \"Quebec Northwest Products Inc.\", avec un capital de §20,000, divisé en 200 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.Rock Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux mai 1952, constituant en corporation: Seymour Elkin, notaire, de Westmount, Edward G.Gauthier, comptable, de Ville St-Laurent, Stanley Stanger, de la Ville de Hampstead, Ralph C.Tees, de Westmount, George L.Haie, de Verdun, tous trois officiers d'une compagnie de fiducie, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire les opérations de perceurs et prospecteurs de mines, sous le nom de \"Rock Corporation Ltd.\" avec un capital de §40,000, divisé en 4,000 actions de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1S36 ouest, rue Sherbrooke, en les cité et district judiciaire tie Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853 L.DÉSILETS.Sterling Paper Mills Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du douze mai 1952, constituant en corporation: Sidney Moldofsky, Harry Miller, tous deux gérants, Maxwell Berlin, agent, en les cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et négocier du papier et de la pulpe et leurs sous-produits et composés, sous le nom de \"Sterling Paper Mills Inc.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations ne sera pas moins que §500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1952.-» L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.The American Advertising Agency Limited Avis est ' donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la property by marriage contract, of J.-Ernest Veilleux, and duly authorized by the latter, J.Gérard Aubé, manager, all of La Sarre, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To manufacture and deal in forest products and in farm products, under the name of \"Quebec Northwest Products Inc.\", with a capital stock of §20,000, divided into 200 shares of §100 each.The head office of the company will be at La Sarre, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of Mav, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Rock Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May 1952, incorporating: Seymour Elkin, Notary, of Westmount, Edward G.Gauthier, Accountant, of the Town of St.Laurent, Stanley Stanger, of the Town of Hampstead, Ralph C.Tecs, of Westmount.George L.Hale, of Verdun, all three Trust Company Officiers, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of drillers and mine locators, under the name of \"Rock Corporation Ltd.\", with a capital stock of §40,000 divided into 4,000 shares of §10 each.The head office of the Company will be at 1836 Sherbrooke St.West, in the City and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of Mav 1952.L.DÉSILETS, 32853-o Deputy Attorney General.Sterling Paper Mills Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have * been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of May 1952, incorporating: Sidney Moldofsky, Harry Miller, both Managers, Maxwell Berlin, Agent, in the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing, and dealing in paper, pulp and by-products and compounds thereof, under the name of \"Sterling Paper Mills Inc.\".The capital stock of the company is divided into 100 shares having no nominal or par value and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be not less than §500.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of Mav 1952.L.DÉSILETS, 32853-0 Deputy Attorney General.The American Advertising Agency Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 1648 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1962, Tome 8J,, A70 26 province de Québec, des lettres patentes en date du huit mai 1052, constituant en corporation: Edgar Reginald Parkins, avocat et conseil en loi de la Reine, Cecil .faines Gagnier, secrétaire, tous deux de Montréal, Roslyn Maxwell Halla-day DuBoyce, avocat, de Dixie, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'annonces et de publicité, sous le nom de \"The American Advertising Agency Limited\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 1,000 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $5,000.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.The Production of Mount St-Hilairc Ltd.La Production de Mont St-Hilaire Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément, à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du huitième jour de mai 1952, constituant en corporation: Ned Jaakobs.réalisateur de la cité de New York, U.S.A., Henri Brodeur, secrétaire, de St-Hilaire, district judiciaire de St-Hyacinthe, Clémence Perron, veuve de feu Frank Warnicker, Mary Segal, toutes deux secrétaires, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Produire, organiser, diriger des productions théâtrales, sous le nom de \"The Production of Mount St-Hilaire Ltd.\", \"La Production de Mont St-Hilaire Ltée\", avec un capital de $300,000, divisé en 3,000 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, distiict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Verdun Rugby Football Club Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix mai 1952, constituant en corporation sans capital-actions; Cordon Charles Robinson, gérant général, Walter Sydney Smaill, vendeur, Archibald Roy Chesley, instituteur, Malcolm Mark Parsons, teneur de livres, Morton Bloch, marchand, William Gibson Liddell, commis.Herbert Auld Holland, représentant de ventes et Jack Ralph Bogante, avocat et conseil en loi de la Reine, de Montréal, Cecil Herbert Til ley, gérant de bureau, Angus McKechnie MacFarlane, instituteur de Verdun, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Organiser, promouvoir et administrer un club athlétique pour l'encouragement et l'avancement des sports et de Fathéltisme en général, sous le nom de \"Verdun Rugby Football Club.\".Le montant auquel est limité le revenu des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $35,000.Province of Quebec, bearing date the eighth day of May 1952, incorporating: Edgar Reginald Parkins, Advocate and Queen's Counsel, Cecil James Gagnier, Secretary, both of Montreal, Roslyn Maxwell Ilalladay DuBoyce, Advocate, of Dixie, all of Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on a general advertising and publicity business, under the name of \"The American Advertising Agency Limited\".The capital stock of the company is divided into 1,000 shares having no nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be 85.000.\" The head oflice of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tins eighth dav of Mav 1952.L.DÉSILETS, 32853-o Deputy Attorney General.The Production of Mount St-IIilaire Ltd.La Production de Mont St-Hilaire Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the eight day of May 1952, incorporating: Ned Jaakobs, Producer, of New-York City, U.S.A., Henri Brodeur, Secretary, of St.Hilaire, Judicial District of St.Hyacinthe, ('lenience Perron, Widow of the late Frank Warnicker, Mary Segal, both Secretaries, of Montreal, Judicial District of Montreal, for the following purposes; To produce, organize, manage, theatrical productions, under the name of \"The Production of Mount St.Hilaire Ltd.\", \"La Production de Mont.St-Hilaire Ltée\", with a capital stock of $300,000, divided into 3,000 shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eight day of Mav 1952.L.DÉSILETS, 32S53-o Deputy Attorney General.Verdun Rugby Football Club Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of May 1952, incorporating without share capital: Gordon Charles Robinson, General Manager, Walter Sydney Smaill, Salesman, Archibald Roy Chesley, Teacher, Malcolm Mark Parsons, Bookkeeper, Morton Bloch, Merchant, William Gibson Liddell, Clerk, Herbert Auld Holland, Sales Representatives ami Jack Ralph Bogante, Advocate and Queen's Counsel, of Montreal, Cecil Herbert Tilley, Office Manager, Angus McKechnie MacFarlane, Teacher, of Verdun, Judicial District of Montreal, for the following purposes: To organize, promote and manage an atheletic club for the encouragement and promotion of sports and athletics generally, under the name of \"Verdun Rugby Football Club.\".The amount.to which the revenue from the immoveable property which the coiporation may possess, is to be limited to $35,000. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol 84, No.26 1649 Le siège social de la corporation sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853 L.DÉSILETS.Victoria Ready Mix Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuf mai 1952.constituant en corporation: Zacharie Roy, industriel, Dame Alice Dugré Roy, ménagère, épouse commune en biens du dit Zacharie.Roy,'dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, Ludger Désilets.mécanicien, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Préparer, transformer, mélanger la pierre, le gravier, le sable, le ciment et autres ingrédients, sous le nom de \"Victoria Ready Mix Inc.\", avec un capital de $75,000» divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le neuf mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILETS.The head office of the Corporation will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Victoria Ready Mix Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the ninth day of May, 1952, incorporating: Zacharie Roy, industrialist, Dame Alice Dugré Roy, housewife, wife common as to property of said Zacharie Roy, duly authorized by the latter for the purposes hereof, Ludger Désilets, mechanic, all of \u2022Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To prepare, transform, mix stone, gravel, sand, cement and other ingredients, under the name of \"Victoria Ready Mix Inc.\", with a capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of May, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Atbanase Siniard Automobile Ltcc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 mai 1952, changeant le nom dé la compagnie \"Les Réparations Si-mard Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 octobre 1951.en celui de \"Athanase Simard Automobile Ltée\".Daté du bureau du Procureur général le 21 mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.Canadian Ribbon Tape Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 15 mai 1952, à la compagnie \"Canadian Ribbon Tape Co.Ltd.\"; augmentant son capital-actions de S30.000 divisé en actions de S10.Daté du bureau du Procureur général le 15 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILETS.Cie de Tabac Terrebonne Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Supplementary Letters Patent Athanase Simard Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-first day of May, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Les Réparations Simard Ltée\", incorporated by letters patent under date of October 22, 1951.to that of \"Athanase Simard Automobile Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of Mav, 1952.L.DÉSILETS, 32S53 Deputy Attorney General.Canadian Ribbon Tape Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the fifteenth day of May, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act.R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Canadien Ribbon Tape Co.Ltd.\", increasing its capital stock by $30,000, divided into shares of $10.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of Mav, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Cie de Tabac Terrebonne Limitée Notice is given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the fifteenth day of May, 1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the 1650 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec .'S juin 1962, Tonus 84, N° 20 Morisset.conformément à l'article 2.de ladite Loi S.R.Q., 1041.chapitre 276.des lettres patentes supplémentaires, en date du 15 niai 1052.changeant le nom de la compagnie \"La Compagnie de Tabac Terrebonne Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 septembre 1946, en celui de \"Cie de Tabac Terrebonne Limitée\", et lui accordant des pouvoirs additionnels.Daté du bureau du Procureur général le 15 mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.DÉSILETS.Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act.K.S.Q.1941, chapter 276, changing the name of the company \"La Compagnie de Tabac Terrebonne Limitée\", incorporated, by letters patent bearing dale the twelfth day of September, 1940.into that of \"Cie cie Tabac Terrebonne Limitée\", anil granting it additional powers.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of Mav.1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Club de Golf do Lorctte Inc.Lorctte Golf Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset.conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941.chapitre 276.des lettres patentes supplémentaires en date du 20 niai 1952.à la compagnie \"Club de Golf de Lorctte lue\".\"Lorctte (îolf Club lue\", augmentant son capital-actions de 820.000 à 870,000; le capital additionel étant divisé en 5.000 actions privilégiées tie 810.Daté du bureau du Procureur général le 20 mai 1952.L'Assistaitt-procurcur génera I.32853-0 L.DÉSILETS.G.IL Montniigny Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941, chapitre 276.des lettres patentes supplémentaires en date du 17 mai 1952, à la compagnie \"G.-II.Montniigny Inc.\".a) accordant les pouvoirs additionnels énunié-rés dans le règlemnt numéro 3 adopté le 2-1 avril 1952; b) changeant son bureau principal de Sillery à Québec.Daté du bureau du Procureur général le 17 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Club «le Golf de Lore!le Inc.Lorctte Golf Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing dale the twentieth day of May.1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred'Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, K.S.Q.19-11.chapter 276, to the company \"Club de (îolf de Lorctte Inc.\", \"Lorctte Golf Club Inc.\", increasing its capital stock from 820.000 to 870.000; tlie additional capital stock being divided into 5,000 preferred shares of 810.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of May, 1952.L.DÉSILETS, 32X53 Deputy Attorney General.G.IL Montniigny Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent, bearing date the 17th day of May.1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941.chapter 276, to the company \"G.-II.Montminy Inc.\" a) granting the additional powers enumerated in By-law number 2 adopted on April 2-1, 1952; //) changing its head office from Sillery to Quebec.Daletl at the office of the Attorney General, Mav 17,1952.L.DÉSILETS, 32S53 Deputy Attorney General.La Peinture Zenith Incorporée Zenith Paint Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accoidé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 mai 1952, à la compagnie \"La Peinture Zenith Incorporée\" \"Zenith Paint Incorporated\": augmentant son capital-actions de 810,000 à 8100,000; ce capital additionnel étant divisé en 1,500 actions ordinaires de S10 chacune, 25.000 actions classe \"B\" de 81 chacune et de 500 actions privilégiées classe \"A\" de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 26 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.La Peinture Zenith Incorporée Zenith Paint Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of May, 1952.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"La Peinture Zenith Incorporée\" \"Zenith Paint Incorporated\": increasing its capital stock from 810.000 to 8100,000; this additional capital being divided into 1,500 common shares of 810 each, 25,000 Class \"B\" shares of 81 each and 500 Class \"A\" prefei red shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, May 26, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol 84, No.26 1651 Quebec Land Company Avis est donne (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représente par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.H.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 2 mai 1952.à la compagnie \"Quebec Land Company\" ratifiant le règlement X° 19 de la compagnie portant son capital-actions de §30.000 à §200.000 par la création de 34,000 nouvelles actions privilégiées de §5 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués au règlement.Daté du bureau du Procureur général le 2 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32S53-o L.DÉSILETS.Record Player Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 31 mai 1952.changeant le nom de la compagnie \"Record Player Mfg.Corp.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 mars 1952, en celui de \"Record Player Corporation\".Daté du bureau du Procureur général le 21 mai 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-o L.DÉSILLTS.Savard, Hodgson & Co.Inc.Savard, Hodgson & Cie, Inc.\u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset.conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941.chapitre 276.des lettres pa> tentes supplémentaires, en date du 19 mai 1952.à la compagnie \"Savard.Hodgson & Co.Inc.\" \u2014 \"Savard.Hodgson & Cie, Inc.\"; augmentant son capital-actions, le capital additionnel étant divisé en 750 actions privilégiées de §100.Daté du bureau du Procureur général le 19 mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-o L.DÉSILETS.Savon Majestic Soap Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset.conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1911.chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 mai 1952.à la compagnie \"Savon Majestic Soap Limitée\"; augmentant son capital-actions de §20,000 à $50,000; le capital additionnel étant divisé en 30.000 actions de §1.Daté du bureau du Procureur général le 17 mai 1952.L'Assistant-procureur général.32S53-o L.DÉSILICTS.Standard Barrels and Drums Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province tic Québec, représenté par M.Alfred Mo- Qucbec Land Company Xoticc is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letter., patent, bearing date the second day of May.1952.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 270.to the company \"Quebec band Company\", ratifying the by-law No.19, of the Company, increasing its capital stock from 830,000 to §200.000 by the creation of 34,000 new preferred shares of §5 each, subject to the rights and restrictions indicated in the by-law.Dated at the ofliee of the Attorney General, this second dav of Mav, 1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General.Record Player Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the twenty-first day of May, 1952.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Record Player Mfg.Corp.\".incorporated by letters patent under date of March 17.1952.into that of \"Record Player C 'orporation\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of Mav.1952.\" L.DÉSILETS, 32S53 - Deputy Attorney General.Sa\\ a rd.Hodgson & Co.Inc.Savard.Hodgson & Cie, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the nineteenth day of May.1952, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset.in conformity with section 2 of the said Act.R.S.Q.1941, chapter 276.to the company \"Savard.Hodgson & Co., Inc.\" - \"Savard.Hodgson & Cie, Inc.\" increasing its capital stock, the additional capital stock to be divided into 750 preferred shares of §100.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of Mav.1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General.Savon Majestic Soap Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the seventeenth day of May.19.52, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act.R.S.Q., 1941.chapter 276, to the company \"Savon Majestic Soap Limitée\", increasing its capital stock from §20,000 to $50,000; the additional capital stock being divided into 30,000 shares of $1.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of Mav.1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General.Standard Barrels and Drums Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of May.1952, were issued by the Lieutenant-Govrnor of 1652 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 8/,, N* 26 risset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 9 mai 1952, à la compagnie \"Standard Barrels and Drums Inc.\"; a) augmentant son capital-actions de $99,000 à $200,000; le capital additionnel étant divisé en 10 actions communes de $100 et en 10,000 actions privilégiées de $10 :/') augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de trois à quatre (3 à 4).Daté du bureau du Procureur general le 9 mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-0 L.1) KSI LETS.the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Standard Barrels and Drums Inc.\"; a) increasing its capital stock from $99,000 to $200,000; the additional capital being divided into 10 common shares of $100, and into 10,000 preferred shares of $10; /;) increasing the number of directors of the company from three to four (3 to J).Dated at the office of the Attorney General, Mav.9.1952.L.DÉSILETS, 32S53 Deputy Attorney General.Syndicat Laurcntien Incorporé Laurent inn Syndicate Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941, chapitre 276.des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 mai 1952, à la compagnie \"Syndicat Laurcntien Inc >rporé\", 1° changeant son nom en celui de \"Syndicat Laurcntien Incorporée\" \u2014 Laurentran Syndicate Incorporated\"; 2° modifiant les dispositions des lettres patentes de la manière énoncée dans le règlement; 3° augmentant le capital-actions ('e la compagnie, le capital additionnel étant divisé en 2,900 actions privilégiées additionnelles de $50 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 11 mai 1952.L'Assistant-procureur général.32853-o L.DÉSILETS.Syndical Laurenlien Incorporé Laùrcntian Syndicale Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec.Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of May, 1952.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act.R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company Syndicat Laurcntien Incorporé\": 1.Changing its name into that of \"Syndicat Laurcntien Incorporé\" \u2014 Laùrcntian Syndicate Incorporated\"; 2.modifying the provisions of the letters patent in the manner set forth in the by-law; 3.increasing the cpital stock of the company, the additional capita] being divided into 2.000 additional preferred shares of $50 each.Dated at the office of the Attorney General, Mav 14, 1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General.Avis divers Miscellaneous Notices AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 2 juin 1952, la fin de l'existence corporative de \"L'Association des Instituteurs Catholiques de Montréal\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.It.Q.1941, chapitre 163, telles qu'ajoutées par la Loi ÏI George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 2 juin 1952.Le Sous-sccrétairc de la Province, 32853-0 JEAN BRUCHÉSI.Archambault Automobile Limitée \"Règlement N° XXI La distribution de l'actif de la compagnie entre les actionnaires est, par les présentes, autorisée au prorata du nombre d'actions détenues par chacun.Vrai sommaire certifié du règlement \"XXI\" de la compagnie \"Archambault Automobile, Ltée\".Drummondville, P.Q., le 17 juin, 1952.Le Secrétaire-trésorier, 32854-0 M.SIGOUIN.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary enacted, under date of June 2, 1952, the termination of the corporate existcne' of \"L'Association des Instituteurs Catholiquee de Montréal\", and such, pursuant to the provis sions of section 20a of the Professional Syndicates-Act.R.S.Q., 1941.chapter 102, as added by the Act II George VI chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this second dav of June, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32853 Under Secretary of the Province.Archambault Automobile Limitée By-lâw \"XX1\" The distribution of the assets of the Company amongst the shreholdcrs ratably to the number of shares held by each is hereby authorized.Certified true summary of By-law \"XXI\" of \"Archambault Automobile Ltée\".Drummondville, P.Q., June 17th, 1952.M.SIGOUIN, 32854-0 .Secretary-treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1653 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Cité Rurale de St-Bruno\", en date du lfi mai 1952, dont le siège social est situé à Saint-Bruno, comté de Lac St-Jean, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 13 juin 1952.Le Sous-secrétaire de la province, 32856-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif d'Egoût de Notre Dame de Lorctte\", en date du b juin 1952, dont le siège social est situé à Village Notre-Dame de Lorctte, comté de Québec, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 12 juin 1952.Le Sous-secrétaire de la province, 32857-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Cité Rurale de St-Bruno\", under date May 16, 1952, whereof the head office is at Saint-Bruno, county of Lake St-Jojin, and the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, June 13, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32856 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourably the Provincial Secretary has duly received th^ third copy of the original of the declaration o foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif d'Egoût de Notre Dame de Lorctte\", under date June 6, 1952, whereof the head oflice is in the village of Notre-Dame de Lorctte, County of Quebec, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the oflice of the Provincial Secretary, June 12, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32857 Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a approuvé, en date du 3 juin 1952, les amendements aux articles 8 et 9 des règlements de \"Temiskaming Community Association Inc.\".tels qu'adoptés à rassemblée générale annuelle tenue le 30 avril 1951, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi «les compagnies de Québec (S.R.Q.19-11, chapitre 276).Le Sous-secrétaire «le la Province.32859 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved on June 3rd, 1952, the amendments to sections 8 and 9 of the By-laws of \"Temiskaming Community Association Inc.\", as adopted at the annual general meeting held on April 30th, 1951, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act (R.S.Q., 1911, chapter 276).(iiven at the office of the Provincial Secretary, the-1th dav of June.1952.JEAN BRUCHÉSI, 32S59-q Under-Secretary of the Province.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi «les syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le 17 juin 1952, le changement «le nom «le \"La Fédération de l'U.C.C.«le Québec-Est\" en celui de \"La Fédération de l'U.\" C.C.«le Ste-Anne de la Pocatière\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi «les syndicats professionnels, S.R.Q.1941.chapitre 162.Donné au bureau «lu Secrétaire de la Province, le 17 juin 1952.Le Sous-secrétaire «le la Province.32S72-o m JEAN BRUCHÉSI.NOTICE OF CHANCE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary, under date of June 17.1952, authorized the change of name of \"La Fédération de l'U.C.C.de Québec-Est\", to that of \"La Fé-«lération de ITJ.C '.< '.de Ste-Anne de la Pocatière\", pursuant to section 7 of the Professional Syndicates' Act.R.S.Q.1941, chapter 162.Dated at the office of the Provincial Secretary, June 17 ,1952.JEAN BRUCHÉSI, 32S72 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné «pic l'honorable Secrétaire de la province a dûment, reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Cercle des Cuniculteurs du district «le Sherbrooke\", en date du 27 mai 1952.«lont le siège social est située à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat «le la Province .Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 12 juin 1952.Le Sous-secrétaire de la Province.32873-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial sScerctary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Cercle des Cuniculteurs du district de Sherbrooke\",under date May 27, 1952.whereof the head office is at Sherbrooke, jduicial district of Saint-Francis, and that the said document has been filed In the archives of the department of the Provincial Secretary.\u2022 Given at the office of the Provincial Secretary, June 12, 1952.JEAN BRUCHÉSI.32873 1 Fnder Secretory of the Province. 1654 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, N\" 26 Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a approuvé, en date du 18 juin 1952, les règlements de \"Drummond Swimmers' Parents Association\", conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.It.Q.chapitre 726).Donné au bureau du Secrétaire delà Province, le 18e jour de juin 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32871 JEAN BRUCHÉSI.La compagnie Sherbrooke Street Realty Corporation donne, par les présentes, avis du décret du règlement spécial N° \"F\" autorisant la compagnie à disposer de ses biens, distribuer son actif au pro rata entre ses actionnaires et procéder subséquemment à la dissolution par voie de procédures d'abandon de chartc.eonformé-ment à l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.Montréal.23 juin 1952.Le Secrétaire.32858 HUGH GRIFFITH.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Croydon Social & Municipal Association Credit Union\", en date du 22 mai 1952, dont le siège social est situé à Croydon, comté de Chambly, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 28 mai 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32974-0 \u2022 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved on June 18th, 1952.the By-laws of \"Drummond Swimmers' Parents Association\", pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec companies Act (R.S.Q., chapter 276).Given at the oflice of the Provincial Secretary the 18th day of June, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 3287 l-o Under-Secretary of the Province.\"Sherbrooke Street Realty Corporation\" hereby gives notice of the enactment of Special By-Law No.\"F ' authorizing the Company to dispose of its property, distribute its assets rate-ably amongst its shareholders and subsequently to proceed to dissolution by way of surrender of Charter proceedings under Section 26 of the Quebec Companies' Act.Montreal.June 23rd, 1952.HUGH GRIFFITH, 32S5S-0 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Croydon Social & Municipal Association Credit Union\", under date the 22nd day of May, 1952, whereof the head oflice is at Croydon, county of Chainbly, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, Mav 28, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32874 Under Secretary of the Province.Charte \u2014 Abandon de .Charter \u2014 Surrender of Archambault Automobile Ltée Avis est donné que la compagnie \"Archambault Automobile Limitée\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social et principale place d'affaires en la cité de Drummondville, s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Drummondville, le 14 juin 1952.La Présidente, 32855-0 Mme J.P.ARCHAMBAULT.Montmorency Patent Holdings Limited La compagnie \"Montmorency Patent Holdings\" Limited donne, par les présentes, avis public que, conformément à la Loi des compagnies de Québec, elle demandera la permission «l'abandonner sa charte.Daté à Québec, ce 20 juin 1952.Le Secrétaire, 32860 LETITIA DUPERRE.AVIS Les Magasins Farmer Ltée Avis est donné conformément à la Loi des compagnies de Québec que la compagnie \"Les Mnga- Noticc is hereby given that the \"Archambault Automobile Ltée\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office and principal place of business in the city of Drummondville, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies* Act.Dated at Drummondville, this 14th day of June, 1952.Mine J.P.ARCHAMBAULT.32855-o President.Montmorency Patent Holdings Limited \"Montmorency Patent Holdings Limited\" hereby gives public notice that, in conformity with the Quebec Companies' Act, it will apply for leave to surrender its charter.Dated at Quebec, this 20th June 1952.LETITIA DUPERRE, 32S60-o Secretary.NOTICE Les Magasins Farmer Ltée Notice is hereby given, accordjng to the Quebec Companies' Act.that the company \"Les Maga- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1962, Vol.84, No.26 1655 sins Farmer Ltée\", demandera la permission sins Farmer Ltée\", will make an application d'abandonner sa charte.for leave to surrender its charter.Montréal, le 1 mai 1952.Montreal, P.Q.May 1st, 1952.Le Secrétaire-trésorier, MARGUERITE COTÉ FARMER, MARGUERITE COTÉ FARMER.Secretarv-Trcasurer.32870-o 32870-o Compagnies dissoutes Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 276, article 26, et sujet a la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Les Constructions de la Vallée Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 23 août 1947.Avis est de plus donné qu'à compter' du 15 juin 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 17 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Companies Dissolved Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec,.1941, chpter 276, section26.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Les Constructions de la Vallée Ltée\", incorporated by letters patent dated August 23, 1947.Notice is also given that from and after June 15, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attomev General, June 17,1952.L.DÉSILETS.32853 Deputy Attorney General.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de QuébccStatuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Mirador Incorporée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 février 1949.Avis est de plus donné qu'A compter du 15 juin 1952 ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 17 juin 1952.L'Assistant-procureur général, 32853-0 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender.of the charter of the company \"Mirador Incorporée\", incorporated by letters patent dated February 28, 1949.Notice is also given that from and after June 15, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attomev General, June 17, 1952.L.DÉSILETS, 32853 Deputy Attorney General.Département de l'Instruction publique Department of Education N° 576-52 Québec, le 17 juin 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Vaudreuil, dans le comté du même nom, les lots 1899 à 1925 inclusivement du cadastre officiel de Vaudreuil et de les annexer à la municipalité scolaire catholique de Hudson, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32820-25-2-o Par 13.O.FILTEAU.N° 395-51 Québec, le 20 juin 1952.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11.juin 1952, de détacher de la municipalité scolaire de Farnham Ouest Paroisse, dans le comté de Missisquoi, les lots du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Romuald-de-Farnham portant les numéros 419, 421, 422 et 426.et de les annexer à la municipalité scolaire de Ste-Brigide, dans le comté d'Iberville.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1952.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32S68-0 O.J.DESAULNIERS.No.576-52 Quebec, June 17, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Vaudreuil, in the county of the same name, lots 1899 to 1925 inclusively, of the official cadastre for Vaudreuil and to annex them to the Catholic school municipality of Hudson, in the same county.Per B.0.FILTEAU, 32820-25-2 For the Superintendent of Education.N° 395-51 Quebec, June 20, 1952.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by order in council dated June 11, 1952, to detach from the school municipality of Farnham West parish, in the county of Missisquoi, the lots of the official cadastre for the parish of Saint-Romuald-de-Farnham bearing numbers 419, 421, 422 and 426, and to annex them to the school municipality of Ste-Brigide, in the county of Iberville.The said order in council to become effective on the first of July, 1952.0.J.DESAULNIERS, 32868 Superintendent of Education. 1656 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1952, Tome 84, Nm 26 No.275-52 Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Dupuy, dans le comté d'Ahi-tibi-oucst, les lots du canton de Desmeloize, portant les numéros 54 à 58 inclusivement des rangs II et III (2 et 3) et les lots 46 et 47 des rangs IV et V (4 et 5), et de les annexer à la municipalité scolaire de Clermont, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.32807-26-2-o 0.J.DESAULNIERS.No.427-52 Québec, le 21 juin 1952.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1952, de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Damase, dans le comté de Matapédia, les lots suivants, tous inclusivement du canton de McNider, savoir: \"5 à 12 du rang IX (9); 9 à 12 du rung X (10); 10 à 34 du rang XI (11) et de les annexer à la municipalité scolaire du village de Saint-Noël, même comté.\" Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1952.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32S08-o O.J.DESAULNIERS.Département des Terres et Forêts No.275-52 Quebec, June 20, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Dupuy, in the county of Abibibi-West, the lots of the township of Desmcloize, bearing numbers 54 et 58 inclusively of ranges II and III (2 and 3) and lots 46 and 47 of ranges IV and V (4 and 5) and to annex them to the school municipality of Clermont, same county.O.J.DESAULNIERS,' 32S67-26-2 Superintendent of Education.No.427-52 Quebec, June 21, 1952.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by order in council dated June 11, 1952, to detach from the school municipality of Saint-Damase,' in the county of Matapédia, the following lots, all inclusively of the Township McNider, to wit: \"5 to 12 range IX (9); 9 to 12 of range X (10); 10 to 34 of range XI (11) and to annex them to the school municipality of the village of Saint-Noël, same county.\" The said order in council to become effective on the first of July, 1952.O.J.DESAULNIERS, 32S6S Superintendent of Education.Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel du village d'Aylmer (ville d'Aylmer), division d'enregistrement de Gati-neau.Avis est par la présente donné que les lots 781-3 à 781-6.781-13 à 781-21, 781-25 à 781-34, 781-36 à 781-107, 781-115 à 781-118, 781-124 à 781-127, 781-132, 781-133, 781-135 à 781-167, 781-172 à 781-177, partie des lots 781-108 à 781-111, 7S1-114, 781-119, 781-123, 781-128, 7S1-129, 781-134, 781-169 à 7S1-171, 781-178; les lots 744-4, 745-4, 745-5.776-1 à 776-4, 777-1, 777-3, 778-2, 778-3; le lot 776 et une partie des lots 744, 715, 777 et 778 sont annulés et le lot 2185 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 juin 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32869-o OVILA BEDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Laprairie (ville de Laprairie), division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que les lots 304-1 à 304-180, 304-183 à 304-228, 305-1 à 305-198, 306-1 à 306-39, 306-73 à 306-76 et une partie des lots 306-40, 300-43 à 306-67, 306-69 et 306-72 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 juin 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre.32869-0 AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai Cadastre of the village of Aylmcr (town of Aylmer), registration division of Gatineau.Notice is hereby given that lots 781-3 to 781-6, 781-13 to 781-21, 781-23 to 781-34, 781-36 to 781-107, 781-115 to 781-118, 7S1-124 to 781-127.781-132, 781-133, 781-135 to 7S1-167, 781-172 to 781-177, part of lots 781-10S to 781-111.781-114, 781-119, 781-123, 781-J28, 781-129, 781-134, 781-169 to 781-171, 781-178; lots 744-4, 745-5.776-1 to 776-4, 777-1, 777-3.778-2, 778-3; lot 776 and part of lots 744, 745, 777 and 778 are cancelled and lot 2185 is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, June the 10th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32869-0 Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the parish of Laprairie (town of Laprairie), registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 304-1 to 304-180, 304-183 to 304-228, 305-1 to 305-198, 306-1 to 306-39, 306-73 to 306-76 and part of lots 306-40, 306-43 to 306-67, 306-69 and 306-72 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, June the 21st, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32869-0 Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1657 AVIS Cadastre officiel revisé de la ville de Lévis, quartier St-Laurent (maintenant cité de Lévis), division d'enregistrement de Lévis.Avis est par la présente donné que les lots 652-360-1 à 652-360-9, 652-373 à 652-3S4; les lots 652-360-10 à 652-360-19.652-386 à 652-431 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 16 juin 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32869-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Potton, division d'enregistrement de Brome.Avis est par la présente donné que les lots 1067-11, 1068-1, 1068-2 sont corrigés et le lot 1067-12 est annulé en vertu des articles 2174 et 2174A du Code civil.Québec, le 13 juin 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32869-0 AVILA BÉDARD.NOTICE Official revised cadastre of the town of Levis, St.Laurent ward (now city of Levis), registration division of Levis.Notice is hereby given that lots 652-360-1 to 652-360-9, 652-373 to 652-384; lots 652-360-10 to 652-360-19, 652-386 to 652-431 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, June the 16th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32869-o Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the township of Potton, Registration division of Brome.Notice is hereby given that lots 1067-11, 1068-1, 106S-2 are corrected and lot 1067-12 is cancelled in virtue of Articles 2174 and 2174A of the civil Code.Quebec, June the 13th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32S69-o Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses des Trois-Rivières et distiict, établi en exécution du décret 1010, du 4 août.1948, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 714 du 11 juin 1952, section \"D\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode de et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet 1952 au 1er juillet 1953; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: «) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 1040, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% de la liste des salaires fixes, commissions, bonis, allocations qu'ils versent à leurs salariés des métiers régis par ledit décret.6) Les artisans assujettis audit décret doivent également verser au Comité paritaire une somme équivalente a J/£ de 1 % du salaire établi dans le décret pour le salarié compagnon le moins rémunéré, soit 830.00 par semaine pour les hommes et S20.00 par semaine pour les femmes, ce qui fera une cotisation mensuelle de 80.60 pour les hommes et 80.50 pour les femmes.c) Les salariés assujettis audit décret doivent verser au Comité paritaire une\" somme équivalente à ]/z de 1% de leurs salaires, commissions, bonis ou allocations.Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of the Barbers and Hairdressers of the district of Trois-Rivières, formed under decree number 1040 of August 4, 1948, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 714 of June 11, 1952, part \"D\" in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163) to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from July 1.1952.to July 1, 1953;such levy is laid in the following manner: a) The professional employers governed by the decree number 1040, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to }/i of 1% of the pay-roll, commissions, bonuses, allocations which they pay to their employees of the trades covered by the said decree.b) The artisans governed by the said decree shall also pay to the Parity Committee a sum equivalent to J/j of 1% of the lowest wage rate established in the decree for journeymen employees, i.e.830.00 per week in the case of male artisans and 820.00 per week in the case of female artisans which will make a monthly assessment of SO.60 for men ami 80.50 for women.c) All the employees governed by the said decree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent t of 1% of their wages, commissions, bonuses or allocations. 1658 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.28 juin 1052, Tome 84, iV° 26 2.Mode de perception Les employeurs professionnels et les artisans régis par le décret doivent faire la remise de leurs cotisations mensuellement au siège social du Comité paritaire (953, rue Royale, Trois-Rivières) .L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent au Comité paritaire et en faire remise audit Comité paritaire mensuellement.Les cotisations doivent être remises au Comité paritaire le ou avant le 10 de chaque mois, c'est-à-dire, les cotisations du mois de juillet sont payables le ou avant le 10 août et ainsi de suite pour chaque mois subséquent.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des Barbiers.Coiffeurs et Coiffeuses des Trois-Rivières et district, pour la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 1er juillet.1953.Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses des TllOIS-Rl VIERES ET DIoTRICT État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entie le 1er juillet 1952 et le 1er juillet 1953.Recettes: Cotisations de 1%:) Employeurs professionnels.8 275.60 Salariés.391.20 Artisans.795.60 Honoraires d'examens.75.00 81,537.40 Débourses: Salaires: Secrétaire.S 300.00 Inspecteur.200.00 Employés de bureau.100.00 Frais de déplacement.662.40 Bureau des examinateurs.40.00 Loyer et éclairage.30.00 Frais judiciaires et professionnels .10.00 Impression et papeterie.50.00 Poste, téléphone et télégraphe.55.00 Dépréciation, ameublement et agencement .5.00 Frais des délégués.60.00 Vérification des livres.20.00 Assurance fidéjussion.5.00 81,537.40 Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 28 juin 1952.32S75-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformé- 2.Mode of collection The professional employers and the artisans governed by the decree shall forward their assesss-ments every month, to the office of the Parity Committee (953 Royale Street.Three Rivers).The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the sums payable to the Parity Committee and remit same to the said Committee every month.The assessments shall be remitted to the Parity Committee on or before the 10th day of each month, i.e.the assessments for July are payable on or before August 10, and so forth, for each subsequent mouth.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present to the Minister of Labour a quarterly report of its financial operations on the following dates: March 31, June 30, September 30, and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of the Barbers and Ha rid ressers of the District of Trois-Rivières, for the period beteween July 1, 1952 and June 1, 1953.Parity Committee ok the Barbers and Hairdressers of the District ok Trois-Rivières Estimate of the receipts and disbursements for the period between July 1, 1952.and July 1, 1953.Receipts: Assessments (^> of 1%): Professional employers.S 275.60 Employees.391.20 Artisans.795.00 Examination fees.75.00 SI.537.40 Disbursements: Salaries: Secretary.S 300.00 Inspector.200.00 Office employees.100.00 Travelling expenses.662.40 Board of examiners.40.00 Rent and lighting.30.00 Judicial and professional lees.10.00 Printing and stationery.50.00 Postage, telephone and telegraph.55.00 Depreciation, furniture and fixtures .5.00 Expenses of delegates.60.00 Auditing.20.00 Guarantee bond.5.00 81,537.40 GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 28 ,1952.32«75-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the QUEBEC OFFICIAI.OAXETTE, Quebeo, June 28th, 1992, Vol.84, No.2b' 1659 mont aux dispositions de la Loi des la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), (pie les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 973 du 30 juin 1948, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur mofifiée, de la façon suivante: Le paragraphe \"a\" «le l'article II sera remplacé par le suivant : \"a) Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend la cité de Québec et le territoire compris dans un rayon de cinquante (50) milles de ses limites ainsi (pie la municipalité de St-Ephrem de Beauce; le décret s'applique aussi aux établissements ayant plus de quinze (15) salariés dans les municipalités d'Andrévilleet de Kivière-du-Loup.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 28 juin 1952.32875-0 provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the metal trades in the district of Quebec, rendered obligatory by the decree number 973 of June, 30 1948, have submitted to him a request to amend the said decree, as amended, as follows: « Subsection.\"«\" of section II will be replaced by the following: \"a) Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree comprises the city of Quebec and the territory included in a radius of fifty (50) miles from its limits and extends to the municipality of St.Ephrem de Beauce; the decree also applies to establishments of the municipalities of Andrcville and Rivière-du-Loup having more than fifteen (15) employees.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties mav wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec.June 28, 1952.32875-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 163 et amendements), qu'à la suite d'une sentence arbitrale rendue le 11 juin 1952, les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 1730 du 23 octobre 1947 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans la région de Québec, lui ont présenté une requête à l'effet d'apporter les modifications suivantes audit décret: .1° A l'article III (Juridiction territoriale), que le sous-paragraphe 3 intitulé \"zone I\" soit modifié en ajoutant à rémunération des cités, villes, municipalités, formant ladite zone I.la cité de Thetford-Mincs et la ville de Black Lake.2° A l'article III, que le sous-paragraphe, intitulé \"Zone II\" soit remplacé par le suivant: \"Zone II: La ville de Rimouski, à compter du 1er octobre 1952.\" 3° Que l'échelle des taux de salaires apparaissant à l'article IV soit remplacée par la suivante: NOTICE OF AMENDMENT The Honorable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q.1911, chapter 163 and amendments), that, following an arbitral award rendered June 11, 1952, the contracting parlies to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 1730 of October 23,\" 1947, as amended, relating to the construction industry in the district of Quebec, have submitted to him a petition to amend the said decree as follows: 1.In section III (territorial judisdiction), paragraph 3 headed \"Zone I\" will be amended by adding the city of Thetford-Mines and the town of Black Lake to the enumeration of cities, towns and municipalities constituting the said zone I.2.In section III.the paragraph headed \"Zone II\" will be replaced by the following: \"Zone II: The town of Rmouski, from October 1,1952.\" 3.The wage scale contained in section IV will be replaced by the following: Salaires horaires \u2014 Hourly rates Métiers \u2014 Trades Zones I II III IV Briqueteur, maçon, plâtrier \u2014 Bricklayer/plasterer, mason.81.60 81.40 81.35 SI.25 Charpentier-menuisier \u2014 Carpenter-joiner.1.40 1.30 1.25 1.15 Compagnon jr, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.30 1.25 1.20 1.10 Calfat \u2014 Caulker.1.10 1.00 0.95 0.85 Peintre \u2014 Painter.1.35 1.25 1.20 1.10 Compagnon jr, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.25 1.15 Manœuvre, Faiseur de mortier.Brasseur de Celanitc.Couleur de blanc, Porteur d'oiseau \u2014 Labourer, Mortar maker.Celanitc mixer/Plaster pourer.Hod carrier.1.05 0.95 0.90 0.80 Jointoyeurs, Finisseur de ciment\u2014Joint pointer, Cement finisher.1.30 1.20 1.15 1.05 Poseur de tuile, marbre et terrazzo \u2014 Tile, marble and terrazzo layer 1.35 1.25 1.20 1.10 Compagnon jr, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.25 1.15 Polisseur de terrazzo à la machine \u2014 Terrazzo polishing machine operator.1.20 1.10 1.05 0.95 Premier semestre \u2014 Fist six months.1.10 1.00 0.95 0.90 Tailleur de pierre sur chantier de construction \u2014 Stone cutter on construction operations.1.60 1.40 1.35 1.25 Poseur d'acier d'armature \u2014 Reinforcing steel erector.1.30 1.25 1.20 1.10 16(30 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1.052, Tome S.'h N° 26 Foreur \u2014Driller.1.25 1.15 1.10 1.00 Préposé au marteau pneumatique \u2014 Pneumatic hammer operator.1.25 1.10 1.05 0.95 Poseur de lattes (hois ou métal) \u2014 Latter (wood or metal).1.25 1.15 1.10 1.00 Préposé aux pelles mécaniques, tracteurs ou grues \u2014 Engincnian- shovcls, tractors, hoisting.1.35 1.20 1.15 1.05 Préposé aux monte-charge non actionnés par la vapeur \u2014 Freight elevator operator, not steam driven.1.25 1.10 1.05 0.95 Préposé aux malaxeurs ou compresseurs \u2014 Engincman-mixers or compressors.T.1.25 1.10 1.05 0.95 Mécanicien de machines fixes et portatives \u2014 Engineman-statiouary and portable machines.1.30 1.15 1.10 1.00 Ferblantier-Couvreur \u2014 Tinsmith-roofer: Compagnon \u2014 Journeyman.1.40 1.30 1.25 1.15 Compagnon jr, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.30 1.20 Mécanicien en isolement d'amiante \u2014 Asbestos insulation mechanic 1.40 1.30 1.25 1.15 Isolement de laine minérale, soufflage par pression \u2014 Steel wool insulation, blower method: Operateur en chef \u2014 Chief operator.1.40 1.30 1.25 1.15 Assistant de l'opérateur \u2014 Assistant operator.1.30 1.20 1.15\"* \\ .05 Aide \u2014 Helper.1.05 0.95 0.90 0.80 Fer et bronze d'ornementation \u2014 Ornamental iron and bronze; Mécanicien ou forgeron \u2014 Mechanic or blacksmith.1.35 1.30 1.25 1.15 Compagnon, jr, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.25 1.20 1.15 1.05 (Jratteur, polisseur et sableur de planchers à la main ou à la machine \u2014 Floor scraper, polisher and sander, by hand or with machine 1.25 1.20 1.15 1.05 Gardien sur chantier (nuit et jour, dimanche et fête) maximum 72 heures par semaine.\u2014 Job watchman (night or day, Sundays and holidays) maximum of 72 hours per week.0.75 0.75 0.75 0.70 Chauffeur de camion employé directement par les entrepreneurs de l'industrie de la construction: 0.80 l'heure, 838.00 par semaine dans la zone I seulement.\u2014 Truck driver employed directly by contractors of the construction industry: 80.80 per hour, 838.00 per week, in zone I only.4° A l'article V intitulée \"Durée de travail\", 4.In scctiln V headed \"Duration of Labour\", que les paragraphes a, b et d soient remplacés par subsections \"a\", \"b\" and \"oration 1633 Bégin et Pépin Ltée.1633 Brouillard Automobile.Limitée.1633 Central Lumber Products Limited .1634 Continental Steel Company Limited.1634 Crémerie Drummondville, Limitée .1634 David W.Armstrong & Son Ltd.1635 Dominion Commodity Co.Ltd.1635 Eastern Traders Ltd.1635 Fly-Master Corporation of Canada.1636 Gagnon Frères Meubles (Port-Alfred) Ltée.1636 Giant Chibougamau Mines Ltd.1636 Glendale Cleaners and Dyers Ltd.1637 Grayhouse Realties Inc.1637 Hamilton Nursing Home Inc.1637 Harnish Fisheries Limited.1638 Hudson Planned Homes Limited.1638 J.E.Hanger of Montreal Ltd.1638 Kennebec Lumber Inc.1639 La Chambre de Commerce des Jeunes de Montmorency.1639 La Cie d'Excavations Bonneau Ltée.1640 La Compagnie Thuot & Goyette Limitée.1640 La Coiporation de l'Hôpital de St- Alexandre des Escoumins.1640 La Ligue des Propriétaires de la Pointeaux-Trembles \u2014 Property Owner's League of la Pointe-aux-Trembles.1641 Le Club des Lions de Québec, Inc.1641 Les Immeubles Bernier Limitée.1642 Mansions Garage (Sales and Service) Limited.1642 Material Industries, Ltd.1642 Montmartre Canadien.1643 Montreal Appliance Service Corporation Ltd.1643 Northfield Holdings Inc.1643 Northland Cleats & Lumber Co.Ltd.1644 Olivier Auto Val d'Or Ltée.*.1644 Opemisca Explorers Limited.1644 P.A.Dauncey Limited.1645 Paid Desormeau, Limitée.1645 P.Hamelin Limitée.1645 Powers School (Canada) Ltd.1646 Promotion & Placements Cie Ltée \u2014 Promotion & Investments Co.Ltd.1646 Quebec Northwest Products Inc.1646 Rock Corporation Ltd.1647 Sterling Paper Mills Inc.1647 The American Advertising Agency Limited .1647 Levis, city.1657 Potton, township.1657 Lauour: Barbers and hairdressers, Trois-Rivières (Levy).1657 Construction, Québec (Amendment).1659 Metal, Quebec (Amendment).1658 Bar Examinations: Lower St.Lawrence, study of law.1661 Bedford, 3rd and 4th year.1662 Hull, practice of law.1662 Laurentides, study of law.1663 Richelieu, practice of law.1663 St.Francis, study of law.1663 St.Francis, practice of law.1663 Sagucnay, practice of law.1662 Letters Patent: Academy Sportswear Limited.1632 Associated Lumber & Pulp Corporation 1633 Bégin et Pépin Ltée.1633 Brouillard Automobile, Limitée.1633 Central Lumber Products Limited .1634 Continental Steel Company Limited.1634 Crémerie Drummondville, Limitée .1634 David W.Armstrong & Son Ltd.1635 Dominion Commodity Co., Ltd.1635 Eastern Traders Ltd.1635 Fly-Master Corporation of ( 'anada.1636 Gagnon Frères Meubles (Port-Alfred) Ltée.1636 Giant Chibougamau Mines Ltd.1636 Glendale Cleaners and Dyers Ltd.1637 Grayhouse Realties Inc.1637 Hamilton Nursing Home Inc.1637 Harnish Fisheries Limited.1638 Hudson Planned Homes Limited.1638 J.E.Hanger of Montreal Ltd.1638 Kennebec Lumber Inc.1639 La Chambre de Commerce des Jeunes de Montmorency.1639 La Cie d'Excavations Bonneau Ltée.1640 La Compagnie Thuot & Goyette Limitée.1640 La Corporation de l'Hôpital de St- Alexandre des Escoumins.1640 La Ligue des Propriétaires de la Pointeaux-Trembles \u2014 Property Owner's League of la Pointe-aux-Trembles.1641 Le Club des Lions de Québec, Inc.1641 Les Immeubles Bernier Limitée.1642 Nansions Garage (Sales and Services) Limited.1642 Material Industries, Ltd.1642 Montmartre Canadien.v 1643 Montreal Appliance Service Corporation Ltd.1643 Northfield Holdings Inc.1643 Northland Cleats & Lumber Co.Ltd.1644 Olivier Auto Val d'Or Ltée.1644 Opemisca Explorers Limited.1644 P.A.Dauncey Limited.1645 Paul Desormeau, Limitée.1645 P.Hamelin Limitée.1645 Powers School (Canada) Ltd.1646 Promotion & Placements Cie Ltée \u2014 Promotion & Investments Co.Ltd.1646 Quebec Northwest Products Inc.1646 Rock Corporation Ltd.1647 Sterling Paper Mills Inc.1647 The American Advertising Agency Limited .1647 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1952, Vol.84, No.26 1673 The Production of Mount St-Hilaire Ltd.\u2014 La Production de Mont St-Hilaire Ltée.1698 Verdun Rugby Football Club.1648 Victoria Ready Mix Inc.1649 Lettres patentas supplémentaires: Athanase Simard Automobile Ltée .1649 Canadian Ribbon Tape Co.Ltd.1649 Cie de Tabac Terrebonne Limitée.1649 Club de Golf de Lorette Inc.\u2014 Lorette Golf Club Inc.1650 G.H.Montminy Inc.1650 La Peinture Zenith Incorporée \u2014 Zenith Paint Incorporated.1650 Quebec Land Company.1651 Record Player Corporation.1651 Savard, Hodgson & Co.Inc.1651 Savon Majestic Soap Limitée.1651 Standard Barrels and Drums Inc.1651 Syndicat Laurcntien Incorporé \u2014 Laùrcntian Syndicate Incorporated.1652 Ministère des Finances: Assurance: The Grand Council of the Catholic Mutual Benefit Association of Canada 1664 Soumissions: St-.ïoscph de Mont-Rolland (correction) 1664 Ventes par li citation: Audet et al vs Audet.,.1664 Ventes pour taxes: Délisle, canton.1665 St-Lambert, cité.1666 St-Cceur-de-Marie, village.1666 VENTES PAR SHÉRIFS: Bedford: Loi fédérale sur les Droits successoraux vs Mintz.1667 Pigeon vs Surprenant.1668 Hull: Lauzon vs Héritiers de R.Marengère.1668 Montréal: Després vs Primeau.1669 Page et al vs Parthenais.1669 Terrebonne: Desjardins vs Jolicceur.1670 Garon et al vs Cardinal.1670 32853-0 The Production of Mount St-Hilaire Ltd.\u2014 La Production de Mont St- Hilaire Ltée.1648 Verdun Rugby Football Club.1648 Victoria Ready Mix Inc.1649 Supplementary Letters Patent: Athanase Simard Automobile Ltée .1649 Canadian Ribbon Tape Co.Ltd.1649 Cie de Tabac Terrebonne Limitée.1649 Club de Golf de Lorctte Inc.\u2014 Lorette Golf Club Inc.1650 G.H.Montminy Inc.1650 La Peinture Zenith Incorporée \u2014 Zenith Paint Incorporated.1650 Quebec Land Company.1651 Record Player Corporation.1651 Savard, Hodgson & Co.Inc.1651 Savon Majestic Soap Limitée.1651 Standard Barrels and Drums Inc.1651 Syndicat Laurentien Incorporé \u2014 Laùrcntian Syndicate Incorporated.1652 Department of Finance: Insurance: The Grand Council of the Catholic Mutual Benefit Association of Canada 1664 Tenders: St-Joscph de Mont-Rolland (correction) 1664 Sales by Licitation: Audet et al vs Audet.1664 Sales for Taxes: Délisle, township.1665 St-Lamber, city.1666 St-Cceur-de-Marie, village.1666 SHERIFFS* SALES: Bedford: The Federal Act concerning the Succession Duties vs Mintz.1667 Pigeon vs Surprenant.1668 Hull: Lauzon vs Heirs of R.Marengère.1668 Montreal: Després vs Primeau.1669 Page et al vs Parthenais.1669 Terrebonne: Desjardins vs Jolicceur.1670 Garon et al vs Cardinal.1670 32853-q Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur «U la Reine.Queen's Printer. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.