Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 avril 1953, samedi 4 (no 14)
[" Tome 85, N° 14 1157 Vol.85, No.14 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par ls gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (pubu shed by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 4 avril 1953 Quebec, Saturday, April 4th, 1953 AVIS AUX INTÉRESSSÊS NOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements Rules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The Queen's meur de la Reine, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upou reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine will be suspended without further notice and qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute without prejudice as regards the rights of the somme versée en plus.Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank mandat de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1168 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, L avril 1953, Tome 86, À'0 U délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés daus une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: Si la douzaine.Abonnement: $7 par année.- N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising co^y not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avqid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u2014 1-52 Lettres patentes Club Richelieu Drummondville Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Antoine Biron, Paul Rousseau, avocats, et Emile Goulet, ingénieur, tous de Drummondville.district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Unir ses membres dans un but charitable afin qu'ils puissent s'entr'aider dans le domaine de la culture personnelle; sous le nom de \"Club Richelieu Drummondville\".Le montailt ququel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Letters Patent Club Richelieu Drummoiidvillc Notice is hereby given that under Part Three of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March 1953.incorporating as a corporation without share-capital: Antoine Biron, Paid Rousseau, advocates, and Emile Goulet, engineer, all of Drummondville, judicial district of Artha-baska, for the following purposes: To group its members together for charitable purposes in order that they may help one another in the field of personal culture, under the name of \"Club Richelieu Drummondville\".The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the corporation will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April J,th, 1953, Vol.S5, No.11 1159 Daté du bureau du Procureur général le six mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-o L.DÊSILETS.Dor val Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1953, constituant en corporation: Armand Hébert, Rosaire Rancourt, entrepreneurs, de Dorval, Paul Trépanier, avocat, de Lachine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs et de constructeurs généraux pour toutes espèces de travaux publics ou privés, sous le nom de \"Dorval Construction Ltd.\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf mars 1953.¦ç* L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DÊSILETS.Eug.Chalifour, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mars 1953, constituant en corporation: Jean Sansfaçon, gérant d'affaires, Thérèse De-mers, secrétaire, Louise Deniers, sténo-dactylo, tous de Sillery, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeur en général, sous le nom de \"Eug.Chalifour, Inc.\", avec un capital de $200,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 1500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sillery, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le sept mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DÊSILETS.Giroux Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf février 1953, constituant en corporation: Emile Giroux, Marcel St-Jean et Gaston Giroux, tous garagistes, de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce et la réparation générale de véhicules, moteurs, engins, machineries, sous le nom de \"Giroux Automobile Ltée\", avec un capital de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf février 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-o L.DÊSILETS.Grenon Frères, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Dated at the office of the Attorney General, the sixth day of March 1953.L.DÊSILETS, 34515 \" Deputy Attorney General.Dorval Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the ninth day of March 1953, incorporating: Armand Hébert, Rosaire Rancourt, contractors, of Dorval, Paul Trépanier, advocate, of Lachine, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders for all kinds of public or private workings, under the name of \"Dorval Construction Ltd.\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the ninth day of March 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.Eug.Chalifour, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March, 1953, incorporating: Jean Sans-façon, business manager, Thérèse Demers, secretary, Louise Demers, steno-typist, all of Sillery, judicial district of Québec for the following purposes: To carry on business in general construction under the name of \"Eug.Chalifour, Inc.\", with a capital stock of $200,000, divided into 500 common shares of $100 each, and into 1500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of March, 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.Giroux Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of February 1953, incorporating: Emile Giroux, Marcel St-Jean and Gaston Giroux, all garage-keepers, of Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: Manufacture and deal in repairs in general, of vehicles, motors, engines, machinery, under the name of \"Giroiat Automobile Ltée\", with a capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company shall be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, the nineteenth dav of February 1953.L.DÊSILETS, 34514 Deputy Attorney General.Grenon Frères, Ltée- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 11 GO GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, h avril 1958, Tome 85, N° 11, été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1953, constituant en corporation: Lorenzo Grenon, Victor Grenon, Jean-Marie Grenon, tous trois industriels, de Bagotville, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous articles dans la confection desquels entrent le ciment, le béton ou leurs dérivés, sous le nom de \"Grenon Frères, Ltée\", avec un capital de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Bagotville, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le six mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DÊSILETS.been granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March 1953, incorporating: Lorenzo Grenon, Victor Grenon, Jean-Marie Grenon, all three industrialists, of Bagotville, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture and deal in all articles, in the fabrication of which, cement, concrete or its byproducts are used, under the name of \"Grenon Frères, Ltée\", with a capital stock of $10,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Bagotville, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, the sixth dav of March 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.Lahcrge, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1953, constituant en corporation: J.-Aimé Labcrge, Paul Laberge, Jean-Pierre Collin, industriels, Léo Laberge, barbier, de Saint-Thomas de Montmagny, Philippe Noël, industriel, de Notre-Dame-du-Rosaire, tous du district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants: Construire, exécuter ou exploiter tout genre de travaux publics ou privés, sous le nom de \"Leberge, Inc.\", avec un capital de $40.000, divisé en 400 actions communes de $50 chacune et en 400 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Thomas-de-Montmagny, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général le neuf mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DÊSILETS.- L'Association des Manufacturiers de Bois de Sciage du Québec The Quebec Lumber Manufaturers' Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1953, constituant en corporation sans capital-actions: James Gordon Russell, marchand de bois, de Cap Chat, district judiciaire de Gaspé, George M.Stearns, marchand de bois, de Mégantic, district judiciaire d'Arthabaska, John Eeward Atkinson, marchand de bois, des cité et district judiciaire de Québec, Jos.-A.Dufresne, industriel, de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, lias £agnon, industriel, de Roberval, district judiciaire de Roberval, Paul Murdock, industriel, de Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, Louis-Philippe Saint-Laurent, industriel, de Luceville, district judiciaire de Rimouski, Raoul Guérette, industriel, d'Estcourt, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Promouvoir les meilleures méthodes d'opérations des terrains forestiers, ainsi que concernant la protection et la conservation des forêts, sous le nom de \"L'Association des Manufacturiers de Bois de Sciage du Québec\"\u2014\"The Quebec Lumber Manufacturers' Association\".Laberge, Inc.\"Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Licutenant-Govcrfibr of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March 1953, incorporating: J.Aimé Laberge, Paul Laberge, Jean-Pierre Collin, industrialists, Léo Laberge, barber, of Saint-Thomas de Montmagny, Philippe Noël, industrialist, of Notre-Dame du Rosaire, all of the judicial district of Montmagny, for the following purposes: To build, execute or to operate in any kind of public or private work, under the name of \"Laberge, Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $50 each and into 400 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Saint-Thomas-de-Montmagny, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General on March ninth, 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.L'Association des Manufacturiers de Bois de Sciage du Québec The Quebec Lumber Manufaturers' Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1953, to incorporate as a corporation without share capital: James Gordon Russell, wood merchant, of Cap Chat, judicial district of Gaspé, George M.Stearns, wood merchant, of Megantic, judicial district of Artha-baska, John Edward Atkinson, wood merchant of the city and judicial district of Quebec, Jos.A.Dufresne, industrialist, of Val d'Or, judicial district of Abitibi, Has Gagnon, industrialist of Roberval, judicial district of Roberval, Paul Murdock, industrialist, of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, Louis-Philippe Saint-Laurent, industrialist of Luceville, judicial district of Rimouski, Raoul Guérette, industrialist, of Escourt, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To promote the best methods of operation in forestry areas, also methods concerning the protection and conservation of forests, under the name of \"L'Association des Manufacturiers de Bois de Sciage du Québec\"\u2014\"The Quebec Lumber Manufacturers' Association\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April Lth, 1953, Vol.85, No.14 1161 Le montunt auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le six mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DESILETS.The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is S 100,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of March, 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.Paradis des Dames Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois mars 1953, constituant en corporation: Sydney Lazarovitz, François Vcilleux, avocats, Madeleine Bilodeau, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises sèches, des vêtements, garnitures de maison, ameublements, chaussures, bijoux, articles de toilette, sous le nom de \"Paradis des Dames Inc.\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le trois mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DÊSILETS.Paradis des Dames Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of March 1953, incorporating: Sydney Lazarovitz, François Veilleux, advocates, Madeleine Bilodeau, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, wearing apparel, household furnishings, furniture, foot-wear, jewellery, toilet articles, under the name of \"Paradis des Dames Inc.\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the third dav of March 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.Paris Style Leather Goods Inc.Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze février 1953, constituant en corporation: David C.Greenfcld, Chaim Steingart, Sucher Brafman.tous manufacturiers, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: \u2022 Exercer le commerce de manufacturiers et dessinateurs d'articles en cuir et de tous produits faits de cuir, plastique, étoffe, sous le nom de \"Paris Style Leather Goods Inc.\", avec un capital de $30,000, divisé en 150 actions ordinaires de 8100 chacune et 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de février 1953.L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.Paris Style Leather Goods Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February, 1953, incorporating: David C.Greenfcld, Chaim Steingart, Suchcr Brafman, all manufacturers of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of leather manufacturers and designers and all products made of leather, plastics, cloth, under the name of \"Paris Style Leather Goods Inc.\", with a capital stock of $30,000, divided into 150 common shares of 8100 each and 150 preferred shares of $100.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of February, 1953.L.DÊSILETS, 34515-0 Deputy Attorney General.Paul-O.Lepage, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1953, constituant en corporation: Jean Trudel, avocat, conseil en loi de la Reine, Louis-Claude Trudel.avocat, Alice Sanche, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Extraire, transformer, et faire le commerce de la pierre, du ciment, sous le nom de \"Paul-O.Lepage, Limitée\" avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Paul-O.Lepage, Limitée \" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March, 1953, incorporating: Jean Trudel, advocate, Queen's Council, Louis-Claude Trudel, advocate, Alice Sanche, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To extract, transform and deal in stone, cement under the name of \"Paul-O.Lepage, Limitée\", with a capital stock of 840,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office offthe company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 1162 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, /, avril 1968, Tome 85, i\\° l/t Daté du bureau du Procureur général le six mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515-0 L.DÊSILETS.Province of Quebec School Curling Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes constituant en corporation sans capital-actions: Charles-Eugène Marchand, industriel, William Gerald Dclancy, marchand, Charles Gregory Michaud, préposé à la vente de billets C.P.R., tous trois de la cité de Québec, Louis-Philippe St-Hilaire.agent général C.P.R., de St-Romuald, Hugh Edward Weyman, ingénieur de Lévis, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Promouvoir et administrer une association d'écoles de curling, sous le nom de \"Province of Quebec School Curling Association\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $25,000.Le siège social de la compagnie sera à 635, rue St-Cyrille, Québec, district judiciaire de Quebec.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-sixième jour de février 1953.L'Assistant-procureur général.34515 L.DÊSILETS.Quebec Catering Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de février 1953, constituant en corporation: John Henry Ernest Colby, Walter Creighton Lcggat, Roland Racicot, avocats, Galen Lee Prime, gérant, Carl Elliott Proctor, teneur de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurant, café, cafétéria et agir comme aubergistes, sous le nom de \"Quebec Catering Limited\", avec un capital de §100,000, divisé en 100.000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de février 1953.\u2022 L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.Raybec Construction Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièie, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-septième jour de février 1953, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Athur Daniel Ruby, comptable agréé, Lewis Jack Manolson, comptable agréé et Irwin Bernard Blond, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Ériger, améliorer, altérer et administrer des édifices et négocier des matériaux de construc- Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of March,* 1953.L.DÊSILETS, 34515 Deputy Attorney General.Province of Quebec School Curling Association Notice is hereby given that under Provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of February, 1953, incorporating without share capital: Charles-Eugène Marchand, industrial, William Gerald Delaney, merchant, Charles Gregory Michaud, ticket agent, C.P.R., all three of the city of Quebec* Louis-Philippe St-Hilaire, general agent, C.P.R., of St-Romuald, Hugh Edward Weyman.engineer, of Levis, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To promote and manage a scholl curling association, under the name of \"Province of Quebec School Curling Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at 635.St-Cyrille, St., Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth day of February, 1953.L.DÊSILETS, 34515-0 Deputy Attorney General.Quebec Catering Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February 1953, incorporating: John Henry Colby, Walter Creighton Lcggat, Roland Racicot, advocates, Galen Lee Prime, manager, Carl Elliott Proctor, bookkeeper, all of the city and,judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurant, café, cafeteria and lodging house keepers, under the name of \"Quebec Catering Limited\", with a capital stock of $100,000.divided into 100,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February 1953.L.DÊSILETS, 34515-o Deputy Attorney General.Raybec Construction Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth day of February, 1953, incorporating: Milton Lowen Klein, advocate, Arthur Daniel Ruby, chartered accountant, Lewis Jack Manolson, chartered accountant, and Irwin Bernard Blond notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To erect, improve, alter and manage buildings and deal in building materials, under the name QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April >,th, 1063, Vol.85, No.11 1163 tion, sous le nom de \"Raybcc Construction Company Inc.\", avec un capital «le $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à .Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, ce dix-septième jour de février 1953.L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.Reliance Trading Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I>oi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes en date «lu cinquième jour de février 1953.constituant en corporation: Johannes Schulzo, marchand, Mary Goldwatcr, secrétaire, épouse séparée «le biens de son mari Sydney Leon Goldwatcr, tous deux «les cité et district judiciaire de Montréal.Robert Ehrmann, marchand, «le la cité de New-York, Etat de New York, un des Etats Unis d'Amérique, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce «le fourru-rer.cuirs, marchandises, articles, marchandises et substances s'y rapportant, sous le nom «le \"Reliance Trading Corp.\" avec un capital «le $10,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, ce cinquième jour «le février 1953.L'Assistant-procureur général, 31515 L.DÊSILETS.Richard Hemsley (Dominion Square) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la premier*' partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, «les lettres patentes en date «lu dix-neuvième jour «le février 1953.constituant en corporation: Zcb Herman, Claire Herman, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Zeb Herman et par son mari dûment autorisée aux fins des présentes, tous deux «le la cité d'Ou-tremont, Charles Herman, gérant, «le la cité de Montréal, tous «lu district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands s'oc-cupant du négoce de toutes variétés «le marchandises ordinairement tenues en magasin par les bijoutiers, orfèvres, horlogers, sous le nom de \"Richard Hemsley (Dominion Square) Ltd.\", avec un capital «le 840,000, divisé en 2,000 actions privilégiées «le $10 chacune et 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.» Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ee-dix-neuvième jour de février 1953.L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.Ritchie Co., Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en daté «lu dix-septième jour «le février 1953, consti- of \"Raybec Construction Company Inc.\", with a capital stock of 840.000, divided into 200 common shares ol 8100.each, and 200 preferred shares of 8100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of February, 1953.L.DÊSILETS.34515-0 Deputy Attorney General.Reliance Trading Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date bte fifth day of February 1953, incorporating; Johannes Schulzc, merchant, Mary Goldwatcr, secretary, wife separate as to property from her husband Sydney Leon Goldwatcr, both of the city and judicial district of Montreal, Robert Ehrmann, merchant, of the city of New York, State of New York, one «>f the United States of America, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, leathers, goods, wares, merchandise and mateiials relating thereto, under the name of \"Reliance Trading Corp.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of S100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of February 1953.L.DÊSILETS, 34515-o Deputy Attorney General.Richard Hemsley (Dominion Square) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of February.1953, incorporating: Zcb Herman.Claire Herman, housewife, wife separate as to property of the said Zeb Herman and by her said husband duly authorized for the purposes hereof, both of the city of Outre-mont, Charles Herman, manager of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as merchants dealing in all classes of merchandise usually carried in stock by jewellers, silver-smiths, watch-makers, clockmakers, under the name of \"Richard Hemsley (Dominion Square ) Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 2,000 preferred shares of $10 each, and 2,000 common shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this nineteenth dav of February, 1953.t.DÊSILETS, 34515-0 Deputy Attorney General.Ritchie Co., Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1953.incorporating: 1164 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, A avril 1958, Tome 85, N° 1A tuant en corporation: Gaston Baribeau, comptable agree, Jeannette Gamachc, sténographe, fille majeure, Gaston Bellerive, comptable, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuilles et de placements, sous le nom de \"Ritchie Co., Ltd.\", avec un capital de 8100,000, divisé en 10,000 actions de 810 chacune.Le siège de la compagnie sera à 118, rue Ra-disson, Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1953.L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.St.Lawrence Clothing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuvième jour de mars 1953, constituant en corporation: Melvin Salmon avocat, Mary Goldwatcr secrétaire, épouse séparée de biens de Sidney Goldwatcr, Tayjana Iszkow, secrétaire, épouse séparée de biens de Mikolaj Iskow, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands d'articles vestimentaires, sous le nom de \"St.Lawrence Clothing Co.Ltd.\", avec un capital de $50,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de mars 1953.L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.Shulman Paper & Twine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-septième jour de février 1953, constituant en corporation: Harry Shulman, Jacob Shulman, maîtres-camionneurs, Sol Shulman, vendeur de Montréal, Aaron Shulman, maître-camionneur, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et négocier toutes sortes de papiers, papier-carton, carton, carton-paille, substituts et produits du papier; et aussi de cordages, cibles, ficelles, sous le nom de \"Shulman Paper & Twine Inc.\", avec un capital de $50,000, divisé en 250 actions ordinaires de S100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 589 rue Montfort, Montréal, district judiciaire de Mont- réal- Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1953.L'Assistant-procureur général, 34515 L.DÊSILETS.Action en séparation de biens (ïaston Baribeau, chartered accountant, Jeannette Gamache, stenographer, spinster, Gaston Bellerive, accountant, all of the city and judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes : To carry on the business of a holding investment company, under the name of \"Ritchie Co., Ltd.\", with a capital stock of $100,000, divided into 10,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 118, Radisson St., Trois-Rivières, in the judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of February, 1953.L.DÊSILETS, 34515-0 Deputy Attorney General.St.Lawrence Clothing Co.Ltd.' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March, 1953, incorporating: Melvin Salmon, advocate, Mary Goldwatcr, secretary, wife separate as to property of Sidney Goldwatcr, Tatjana Is/.kow, secretary, wife separate as to property of Mikolaj Iszkow, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business of manufacturers and dealers in wearing apparel, under the name of \"St.Lawrence Clothing Co.Ltd.\", with a capital stock of $50,000, divided into 100 common shares of $100 each, and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this ninth dav of March, 1953.L.DÊSILETS, 34515-o Deputy Attorney General.Shulman Paper & Twine Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1953, incorporating: Harry Shulman, Jacob Shulman, masters cartels Sol Shulman, salesman, of Montreal, Aaron Shulman, master Carter, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in any and all kinds of papers, paper-board, cardboard, strawboard, paper substitutes and paper materials; and in cordage, ropes, twines, under the name of \"Shulman Paper & Twine Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 250 common shares of $100.each, and 250 preferred shares of $100.each.The head office of the company will be at 589 Montfort St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of February, 1953.L.DÊSILETS, 34515-0 Deputy Attorney General.Action for separation as to property Canada, Province de Québec, district de Canada, Province of Quebec, District of Mont-Montréal, Cour Supérieur,iN\\329912.Dame real, Superior Court, No.329912.Dame Betty QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April Aih, 1953, Vol.86, No.U 1165 Betty Gallow, épouse commune en biens de Hyman Arlin, marchand, des cité et district de Montréal, demanderesse vs Hyman Arlin, époux de la demanderesse, du même endroit, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée dans la présente cause, le 10c jour de mars 1953.Montréal, le 23 mars 1953.Les Procureurs de la demanderesse, MERGLER & MERGLER, 637 ouest, rue Craig, 34535 Montréal, Québec.Action en séparation de corps et de biens Canada, Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 329652.Dame Elsie May Wright, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Robert Henry Wilkie, steamfitter des mêmes lieux, cette dernière autorisée aux fins des présentes par jugement de cette Cour, demanderesse, vs Henry Robert Wilkie, des cité et district de Montréal, défendeur.AVIS Une action en séparation de corps et de biens a été prise par la demanderesse contre le défendeur le 4 mars 1953.Dont avis.Montréal 25 mars 1953.Le Député-protonotaire, C.S.M., J.B.CARBONNEAU.Le Procureur de la demanderesse, 34547-0 Me.YVES PELLETIER.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 335 Québec, le 19 mars 1953.Present: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil Concernant le nouveau développement minier dans les régions éloignées du Nouveau-Québec.\"Il est ordonne, de plus: Qu'une étendue, désignée bloc C et lisérée en bleu sur le plan annexé à la dite proposition, soit réservée et soustraite au jalonnement en claims miniers pour une période de douze mois, à compter du 16 mars 1953.Cette étendue, d'une superficie d'environ cent (100) milles carrés, a pour limite sud une ligne est-ouest d'une longueur de trois milles, dont l'extrémité ouest se trouve au poteau N° 4 du claim C-60632 cl.l, à l'est et à l'ouest par deux lignes de direction nord astronomique se prolongeant jusqu'au rivage du détroit d'Hudson.\" (Extrait.) Greffier Suppléant du Conseil Exécutif, 34531-0 (Signe) C.LARICHELIÈRE.Gallow, wife common as to property of Hyman Arlin, merchant, of the City ami District of Montreal, plaintiff, vs Hyman Arlin,.husband of plaintiff, of the same place, defendant.An action in separation of property has been instituted in this present cause on the 10th day of March 1953.Montreal, March 23rd, 1953.MERGLER & MERGLER, Attorneys for plaintiff, 637 Craig St.West, 34535-0 Montreal, Quebec.Action for Separation as to Bed and Board Canada, Province de Québec, District of Montreal, Superior Court, No.329652.Dame Elsie May Wright, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Robert Henry Wilkie, steamfitter, of the same place, the latter hereby authorized by a judgment of the Court, plaintiff; vs Henry Robert Wilkie, of the city and district of Montreal, defendant.NOTICE An action for separation as to bed and board has been taken by the plaintiff against the defendant on March 4, 1953.Therefore, this notice.Montreal, March 25, 1953.J.B.CARBONNEAU, Deputy Prothonotary, S.C.M.Me.YVES PELLETIER.34547 Attorney for the plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 335 Quebec, March 19, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council Concerning new mining development in the outlying regions, of New Quebec.It is ordained, moreover: That an area, designated as Block C and outlined in blue on the plan annexed to the said project, be reserved and withdrawn from staking for a pariod of twelve months, as from March 16, 1953.This area, covering a surface of about one hundred (100) square miles, is limited to the south by an east-western line, three miles in length, of which the uttermost western limit is located at Post 4 of Claim C-60632 cl.l, to the east and west by two lines running in an astronomical northern direction, extending as far as the banks of the Strait of Hudson.(Excerpt.) Signed: C.LARICHELIÈRE, 34531 Acting Clerk of the Executive Council. 1166 GAZETTE OFFICIEUX DE QUÉBEC, Québec, J, avril 1968, Tome 85, N° l/f ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 374 Québec, le 26 mars 1953.Présent: Le Lieutenant-(ïouvcrneur-en-Conscil.Section \"A\" concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de l'imprimerie dans la région de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de l'imprimerie dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 141 du S février 1951.amendé par les arrêtés en conseil numéros 68-G et 1336-D des 31 janvier et 23 décembre 1952, ont présente au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender ledit, décret.Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 21 février 1953; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 141, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article V est rem- placé par le suivant: \"a) Travail de jour: Classe \"A\": l'heure Typographe, opérateurs de claviers et fondeuses, électrotypeur.$1.575 Finisseur-doreur en reliure.1.575 Clicheur.1.56 Pressier.1.55 Relieur.1.51 Photograveur et opérateur de caméra .1.51 Aide: 1ère année.0.60 2ème année.0.64 Classe \"B\": Typographe, opérateur de claviers et fondeuses.1.525 Finisseur-doreur en reliure.1.525 Pressier à l'aniline (sacs en papier).1.53 Clicheur.1.52 Pressier.1.51 Relieur.1.48 Aide: 1ère année.0.60 2ème année.0.64 Classe \"C\": Typographe, opérateur de claviers et fondeuses.1 \u2022 475 Finisseur-doreur en reliure.1.475 Clicheur.147 Pressier.1 \u2022 46 Relieur.1.44 Aide: 1ère année.0.60 2ème année.0.64 Classe \"D\": Typographe.1.27 Pressier sur plateau.1 -27 Classe \"E\": Relieur.1.42 Finisseur-doreur en reliure.1.435\" 2° Le paragraphe \"d\" de l'article V est remplacé par le suivant: \"d) Apprentis: Les apprentis doivent recevoir les salaires minima suivants, basés sur leur certificat de qualification : ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 374 Québec, March 26, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.l'art \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the printing industry in the district of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the printing industry in the district of Quebec, rendered obligatory by the decree number 141 of February 8, 1951, and amended by Orders in Council Nos.68-G ami 1336-D of January 31 and December 23, 1952, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of February 21, 1953; Whereas the objections raised have been considered, as required by the Act; It is okiikm;d.therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 141, be amended as follows: 1.Subsection \"a\" of section V is replaced by the following: \"a) Day shift: Class \"A\" Ver hour Typographer, keyboard, caster operator and elect rotyper.81.575 Bookbinding finisher-gilder.1.575 Stereotypcr.L .56 \u2022\u2022 Pressman.1.55 Bookbinder.1.51 Photo-engraver and camera operator .1.51 Helper: 1st year.0.60 2nd year.0.64 Class \"B\": Typographer, keyboard and caster operator.1.525 Bookbinding finisher-gilder.1.525 Aniline press (paper bags).1.53 Stereotypcr.1.52 Pressman.1.51 Bookbinder.1.48 Helper: 1st year.0.60 2nd vcar.0.64 Class C\": Typographer, keyboard and caster oper- 1 ator.1.475 Bookbinding finisher-gilder.1.475 Stereotypcr.1.47 Pressman.1.46 Bookbinder.1.44 Helper: 1st year.0.60 2nd year.0.64 Class \"D\": Typographer.1.27 Pressman on platen press.1.27 Class \"E\": Bookbinder.1.42 Bookbinding finsihcr-gilder.1.435\" 2.Subsection \"d\" of section V is replaced by the following: \"d) Apprentices: Apprentices shall receive the following minimum wages based on their competency card : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 4th, 1963, Vol.86, No.14 1167 Par semaine Classes 1ère année.$19.50 $18.00 $18.00 2cme année.24.50 23.00 22.00 3èmc année.28.50 27.00 25.00 4èmc année.32.50 31.00 28.00 5èine année: 1er semestre.37.50 36.00 33.00 2ème semestre .43.00 42.00 38.00 ('es salaires sont payables sur la base horaire.\" 3° Les paragraphes \"g\" et \"A\" de l'article V sont remplacés par les suivants: \"g) Les filles du département de reliure doivent recevoir: par semaine 1ère année.1er semestre.$17.00 1ère année, 2ème semestre.18.00 2èine année.1er semestre.20.00 2ème année, 2ème semestre.21.00 3èmc année, 1er semestre.22.00 3ème année, 2èmc semestre.26.00 \u2022lème année, 1er semestre.2&.00 4ème année, 2ème semestre.30.00 Ces salaires sont payables sur la base horaire.\" \"h) 1.Dans les comtés de Lévis et Lotbinière, bien que faisant partie du district judiciaire de Québec, la cédule des salaires peut toutefois être réduite de trois pour cent (3%) et le travail supplémentaire être rémunéré au taux de salaire et demi.2.Dans les districts judiciaires autres que celui de Québec, la cédule des salaires peut, toutefois, être réduite de dix pour cent (10%) et le travail supplémentaire être rémunéré au taux de salaire et demi.\" 4° Le paragraphe \"d\" suivant est ajouté à l'article VIII: \"d) En autant que ce soit un jour ouvrable, le jour de la Confédération doit être payé au taux des heures régulières de travail, qu'il soit chômé ou non par l'atelier.\" 5° Les paragraphes \"g'\\ \"h\" et \"i\" de l'article IX sont radiés et remplacés par les suivants: \"g) Les compagnons et les apprentis typographes, porteurs d'une carte de cinquième année ont le droit (l'exécuter dvi travail productif sur les machines à composer.Toutefois, tout atelier qui à cause de pénurie de main d'oeuvre, ne peut se conformer à cette clause a le droit d'employer un appicnti de quatrième année, deuxième semestre, lequel doit recevoir un salaire proportionnel à son rendement jusqu'à ce qu'il atteigne un rendement minimum de 3,500 ems à l'heure auquel cas il doit recevoir son salaire de compagnon.\" \"h) Tous les certificats de qualification sont attribués exclusivement par le Bureau des Examinateurs du Comité paritaire.\" \"i) Tout apprenti du district judiciaire de Québec assujetti au présent décret et qui n'aurait pas fréquenté dans un autre district judiciaire, une école d'imprimerie régie par la Loi de l'enseignement spécialisé, est tenu de suivre les cours de perfectionnement qui sont donnés sous les auspices d'une école régie par la Loi de l'enseignement spécialisé.\" \"j) Les apprentis qui ont fréquenté une école d'imprimerie régie par la Loi de renseignement spécialisé doivent obtenir des crédits d'apprentissage proportionnés à la durée de leurs études et aux résultats de leurs examens.!' k) Les présentes ne s'appliquent pas aux élèves de moins de seize (16) ans d'une institution d'assistance publique régie par la Loi de l'Assistance Publique (Statuts refondus de Québec 1941 chapitre 187).Per week Classes \"A\" \"B\"-UC\"'D\"-\"E\" lsryear.$19.50 $18.00 $18.00 2nd year.24.50 23.00 22.00 3rd year.28.50 27.00 25.00 4th year.32.50 31.00 28 00 5th year: first six months .37.50 36.00 33.00 second six months.43.50 42.00 38.00 These wages are payable on an hourly basis\".3.Subsections \"g\" and \"A\" of section V are replaced by the following: \"g) Bookbinding female employees shall receive per week 1st year, first six months.$17.00 1st year, second six months.18.00 2nd year, first six months.20.00 2nd year, second six months.21.00 3rd year, fisrt six months.22.00 3rd year, second six months.26.00 4th year, first six months.28.00 4th year, second six months.30.00 The above wages are payable on an hourly basis.\" \"h) 1.In Levis and Lotbinière counties, although included in the judicial district of Quebec, the wage scale may be reduced by three percent (3%) and overtime be paid time and one half.2.In the judicial districts other than that of Quebec, the wage scale may be reduced by ten percent (10%) and overtime may be remu-rated at the rate of time and a half.\" 4.The following subsection \"d\" is added to section Vlil: \"d) When falling on a working day, Confederation Day shall be paid straight time, whether worked or not by the shop.\" 5.Subsections \"g\", \"k\" and \"t\" of section IX are deleted and replaced by the following: \"g) Apprentice and journeyman typographer holding a fifth year card may do productive work on composing machines.However, in any shop unable to abide by this clause because of labour shortage, the employer may employ an apprentice of the fourth year, second six months, who shall receive wages proportional to his work until he attains a minimum output of 3,500 ems per hour, in which case he is to receive the journeyman's rate of pay.\" \"h) All competency cards are issued only by the Board of Examiners of the Parity Committee\" \"i) Every apprentice of the judicial district of Quebec governed by the present decree and who has not attended in another judicial district a printing school under the Specialized Schools Act shall follow refresher courses given under the auspices of a school governed by the Specialized Schools Act.\",;') Apprentices who have attended a prinitng school under the specialized Schools Act shall be credited, as regards apprenticeship, in proportion to the duration of their studies and to the results of their examinations.\" k) This section does not apply to persons under sixteen years of age in a public relief institution subject to the Quebec Public Charities Act (R.S.Q., 1941, chapter 187). 1108 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, A avril 1053, Tome 85, N° II, 6° Le premier alinéa du paragraphe \"b\" de Particle X est remplacé par le suivant: \"b) Dans les départements des presses ou de elicherie et dans les ateliers de photogravure, d'électrotypic et d'offset, il ne doit pas y avoir plus d'un apprenti par trois compagnons ou fraction de ce nombre.\" 7° Les paragraphes \"/\" et \"g\" de l'article X sont radiés.8° La première phrase de l'article XVII est remplacée par la suivante: \"Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1953 inclusivement.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 374 Québec, le 20 mars 1953.Present: Le Lieutenant-Gouverncur-en-Conscil.Section \"B\" Concernant une modification du décret ralatif à l'industrie du fer et du bronze d'ornementation dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du fer et du bronze d'ornementation dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 1256 du 16 novembre 1950, amendé par les arrêtés en conseil numéros 290-E, 506-B, 757-D et 1155-E des 22 mars, 15 mai, 19 juillet et 17 octobre 1951, et 251-A du 5 mars 1953, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet «l'amender ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 14 février 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret numéro 1256, soit modifié comme suit: Les taux de salaires établis pour la zone II, à l'article II, sont remplacés par les suivants: \"Zone II Classifications: Taux horaires minima A compter du 1er mai 1953 Mécanicien.$1.10 81.20 Ajusteur.0.99 1.10 Forgeron.0.99 1.10 Aide.0.88 0.97\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Greffier suppléant du Conseil Exécutif ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 374 Québec, le 26 mars 1953.Present: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conscil.'6.The first paragraph of subsection \"b\" of section X is replaced by the following: 'b) In press or stereotyping departments, and in photogravure, electrotyping and offset establishments, there shall not be more than one (1) apprentice to each three (3) journeymen or fraction thereof.\" 7.Subsections \"f\" and \"g\" of section X arc deleted.8.The first sentence of section XVII is replaced by the following: \"The present decree remains in force until December 31, 1953, inclusive.\" (Document \"A\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 374 Quebec, March 26, 1953.Present : The Lieutenant-Governor in Council.Part \"B\" Concerning an amendment of the decree relating to the ornamental iron and bronze industry in the district of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the ornamental iron and bronze industry in the district of Montreal, rendered obligatory by the decree number 1256 of November 16, 1950, and amended by Orders in Council 290-E, 506-B, 757-D and 1155-E of March 22.May 15, July 19 and October 171951, arid 251-A of March 5, 1953, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree, as amended; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of February 14, 1953; Whereas no objection has been made against its approval; It is ordored, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1256, be amended as follows: The wages rates for Zone II, mentioned in section II, are replaced by the following: \"Zone II Classification: \u2022 Minimum hourly Rales From May I, 1953 Mechanic.$1.10 $1.20 Fitter.0.99 1.10 Blacksmith.0.99 1.10 Helper.0.88 0.97\" (Document \"B\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Acting clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 374 Quebec, March 26,1953.Ç Present: The Lieutenant-Governor in Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April ith, 1958, Vol 85, No.1A 1169 Section \"C\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le décret numéro 411 du 17 avril 1952 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de' la construction dans la région de Montréal, soit prolongé jusqu'à 1er juillet 1953.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 34516-o Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 374 Québec, le 26 mars 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"D\" Concernant l'addition d'une partie co-contrac-tante \u2014 décret relatif à l'industrie de la construction dans la région des Cantons de l'Est.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), la Corporation des Maîtres-Électriciens de la Province de Québec, Section de Sherbrooke, a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contrac-tante à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans la région des Cantons de l'Est, rendue obligatoire par le décret numéro 1519 du 18 septembre 1947, amendé par les arrêtés en conseil numéros 1233-A et 1634-B des 22 septembre et 2 décembre 1948, 1316-B du 24 novembre 1949, 146-A et 973-A des 1er février et 30 août 1950, 350-B, 541-B et 926-F des 4 avril, 30 mai et 22 août 1951 et 271-G et 787-A des 20 mars et 23 juillet 1952; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 31 janvier 1953; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail : Que ladite requête soit acceptée et, qu'en conséquence, ledit décret numéro 1519 soit modifié en y ajoutant le nom de \"La Corporation des Maître-Électriciens de la Province de Québec, Section de Sherbrooke\", comme partie contractante de première part.(Document \"D\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Greffier suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 374 Québec, le 26 mars 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"E\" Concernant l'addition d'une partie co-contrac- Part \"C\" Concerning an extension of the decree relating to the construction industry and trades in the district of Montreal.It is ordained, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the decree No.411 of April 17, 1953, as amended, relating to the construction industry and trades in the district of Montreal, be extended until July 1st, 1953.(Document \"C\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 374 Quebec, March 26, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"D\" Concerning the adding of a co-contracting party\u2014decree relating to the construction industry in the Eastern Townships District.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), The Corporation of Master Electricians of the Province of Quebec, Sherbrooke Branch, has submitted to the Minister of Labour a petition to be accepted as co-contracting party to the collective labour agreement relating to the construction industry in the Eastern Townships District, rendered obligatory by the decree No.1519 of September 18, 1947, and amended by Orders in Council Nos.1233-A and 1634-B of September 22 and December 2, 1948, 1316-B of November 24, 1949, 146-A and 973-A of February 1st and August 30, 1950, 350-B, 541-B and 926-F of April 4, Mav 30 and August 22, 1951, and 271-G and 787-A of March 20 and July 23,1952; Whereas the said petition was'published in the Quebec Official Gazette, issue of January 31, 1953; Whereas no objection was raised against its approval ; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said petition be accepted and that, consequently, the said decree No.1519 be amended by adding the name of \"The Corporation of Master Electricians of the Province of Quebec, Sherbrooke Branch\" as contracting party of the first part.(Document \"D\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 374 Quebec, March 26, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"E\" Concerning the adding of a co-contracting 1170 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, /, avril 1963, Tome 86, N° 1J, tante \u2014 décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés de Terrebonne et Labelle.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), la Corporation des Maîtres-Électriciens de la province de Québec, Section des Laurentides, a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante à la convention collective de travail relative à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés de Terrebonne et Labelle, rendue obligatoire par le décret numéro 657 du 13 mai 1948, amendé par les arrêtés en conseil numéros 971-E du 30 juin 1948, 623-A et 1085-B des 15 juin et 28 septembre 1949, 225-B, 915-D, 973-A et 1177-B des 22 février, 9 et 30 août et 26 octobre 1950, 926-H et 1228-E des 22 août et 31 octobre 1951, 71-C, 387-C et 788-D des 31 janvier, 9 avril et 23 juillet 1952; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 31 janvier 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ladite requête soit acceptée et, qu'en conséquence, ledit décret numéro 657 soit modifié en y ajoutant le nom de \"La Corporation des Maîtres-Electriciens de la province de Québec, Section des Laurentides\", comme partie contractante de deuxième part.(Document \"E\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 374 Québec, le 26 mars 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"H\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 504-1$ du 7 mai 1952, soit prolongé jusqu'au 1er juillet 1953, aux mêmes taux et conditions.C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.Assemblées Richelieu Bridge Company Limited Avis d'Assemblée L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de \"Richelieu Bridge Company Limited\" aura lieu au bureau de la compagnie à Saint-Jean, P.party \u2014 decree relating to the construction industry and trades in the counties of Terrebonne and Labelle.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), The Corporation of Master Electricians of the Province of Quebec, Laurentidc Branch, has submitted to the Minister of Labour a petition to be accepted as co-contracting party to the collective labour agreement relating to the construction industry and trades in the counties of Terrebonne and Labelle, rendered obligatory by the decree No.657 of May 13, 1948, and amended by Orders in Council Nos.971-E of June 30, 1938, 623-A and 1085-B of June 15 and September 28, 1949, 225-B, 915-D, 973-A and 1177-B of February 22, August 9 and 30 and October 26, 1950, 926-H and 1228-E of August 22 and October 31, 1951, 71-C, 387-C and 788-D of January 31, April 9 and July 23, 1952; Whereas the said petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of Januarv 31, 1953; Wheruas no objection was raised against its approval 7 It is ordered, therefore, on the recommen, dation of the Honourable the Minister of Labour- That the said petition be accepted and that, consequently, the said decree No.657 be amended by adding the name of \"The Corporation of Master Electricians of the Province of Quebec, Laurentide Branch\" as contracting party of the second part.(Document \"E\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Acting-Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 374 Quebec, March 26, 1953.Present: The Lieutenant-Govcrnor-in-Council.Part \"IF' Concerning an extension of the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal.It is ordered, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal, authorized by a by-law approved by Order in Council No.504-B of May 7, 1952, be extended until July 1st, 1953, with the same rate and conditions.C.LARICHELIÈRE, 34516-0 Acting Clerk oHhe Executive Council.Meetings Richelieu Bridge Company Limited Notice of Meeting The annual general meeting of shareholders of \"Richelieu Bridge Company Limited\" will he held at the Company's office, in St.John, P.Q., t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April /,th, 1953, Vol.86, No.U, 1171 Q.samedi le 18 avril 1953 à 2.00 lires p.m.au bureau «lu président.Le Secrétaire-trésorier, 34518-0 YVES DELAND.AVIS Avis est, pajf les présentes, donné que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie \"Quebec Central Railway Company\", sera tenue aux bureau de la compagnie \"Canadian Pacific Railway Company\", Montréal, Canada, mercredi, le 15e jour d'avril 1953, à onze heures du matin, pour l'élection de deux directeurs représentant les obligataires et, en général, pour la transaction de toute autre affaire.Les actionnaires enregistrés le 1 le jour de mars 1953 peuvent assister et voter à l'assemblée.Daté à Montréal, Canada, le 2e jour de-mars 1953.Le Secrétaire, 34433-12-3 C.NIDEROST, Avis divers Saturday, April 18, 1953, at 2.00 o'clock p.m., in the President's office.YVES DELAND, 34518 Secretary-Treasurer.NOTICE Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of \"Quebec Central Railway Company\" will be held at the office of the Canadian Pacific Railway Company, Montreal, Canada, on Wednesday, the 15th day of April, 1953, at the hour of eleven o'clock in the forenoon, for the election of two Directors representing the Security Holders and, for the transaction of business generally.Stockholders of record on the 11th day of March, 1953, may attend and vote.Dated at Montreal, Canada, this 2nd day of March, 1953.C.NIDEROST, 34433-12-3-0 Secretary.Miscellaneous Notices Croydon Furniture Mfg.Co.Ltd.lièglemenl .V° 50 Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs de la compagnie de trois à six.Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est.par les présentes, augmenté de trois (3) à six (6); 2.Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendéx pour se conformer au précédent.Daté à Montréal, P.Q., 19 mars 1953.(Sceau) Le Secrétaire.34519 G.A.ALLISON.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Le Syndicat de la Salle Paroissiale de St-Damien de Brandon\", en date du 14 mars 1953, dont le siège social est situé à Saint-Damicn-de-Brandon, dans le comté de Berthier, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétairiat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 18 mars 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Provinse, 34520-o LUCIEN DARVEAU.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"The Red Reel Credit Union\", en date du 10 mars 1953.dont le siège social est situé à Montréal-Est, dans le district judiciair de Montréal, et que ce documenta été déposé dans les archives du Secrétairat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 20 mars 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34523-0 LUCIEN DARVEAU.Croydon Furniture Mfo.Co.Ltd.By-Law No.50 A By-Law to increase the number of Directors of the Company from three to six.Be it enacted and it is hereby enacted as a By-Law of the Company as follows: 1.The number of Directors of the Company be and the same is hereby increased from three (3) to six (6); 2.The By-Laws of the Company be and the same are hereby amended to agree with the foregoing.Dated at Montreal, P.Q., March 19th, 1953.(Seal) G.A.ALLISON, 34519-0 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Le Syndicat de la Salle Paroissiale de St Damien de Brandon\" under date of March 14, 1953 whereof the head office is at Saint-Damien-de-Barndon, in the county of Berthier, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, on March 18, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34520 Acting Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"The Red Reel Credit Union\" under date March 16, 1953 whereof the head office is at Montreal-East, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, March 20, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34523 Acting Under Secretary of the Province. 1172 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 avril 1963, Tome 85, N° 14 Montreal Stevedoring Corporation' \u2022 Règlement onze Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs île quatre à huit.Qu'il soit et il est, par [les présentes, décrété que le règlement trois de la compagnie est amendé en rayant l'article 1 et en y substituant le suivant: \"Article 1.Nombre des directeurs.Le bureau de direction de la compagnie sera composé de huit directeurs\".Certifié vraie copie: Daté en la cité de Westmount, P.Q., ce 3e jour de mars 1953.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 34521 EDWARD IRWIN.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le 1G mars 1953, le changement de nom de \"Le Syndicat National Catholique des Charpentiers Menuisiers, Inc.des Chutes Shawinigan*\" en celui de \"Syndicat des Charpentiers menuisiers de Shawinigan Falls\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 18 mars 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34522-0 LUCIEN DARVEAU.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Le Garage Coopératif de Victoriaville\", en date du 25 mars 1953 dont le siège social est situé à Victoriaville, dans le comté d'Arthabaska, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 27 mars 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34526-0 LUCIEN DARVEAU.Avis est donné que, sur la recommandation de F Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 25 mars 1953, le règlement, tel qu'adopté le 20 août 1929, le règlement N° 1 (compte de banque), tel qu'adopté le 20 août 1929, le règlement N° 2 (documents à être signés), tel qu'adopté le 30 août 1929, le règlement N° 3a, tel qu'adopté le 4 septembre 1929, le règlement N° 4, autorisant l'émission de 8230,000.d'obligations, tel qu'adopté le 23 novembre 1929, le règlement N° 5, tel qu'adopté le 21 mars 1930, le règlement N° 6, tel qu'adopté le 11 avril 1930, le règlement N° 7 autorisant l'émission de §225,000.d'obligations, tel qu'adopté le 9 mai 1930, le règlement N° 8, autorisant l'émission d'obligations au montant de $80,000., tel qu'adopté le 13 février 1933, le règlement N° 9, donnant une garantie additionnelle pour les obligations au montant de $225,000., tel qu'adopté le 13 février 1933, le règlement N° 11, tel qu'adopté le 15 avril 1935, le règlement N° 13, autorisant l'émis- Montreal Stevedoring Corporation By-Law eleven A By-law to increase the number of Directors from four to eight.Be it and it is hereby enacteed that By-law Three of the Company is amended by deleting Article 1 thereof and by substituting therefor the following: \"Article 1.Number of Directors.The Board of Directors of the Company shall consist of eight Directors\".Certified true coyp: Dated at the city of Westmount, P.Q., this 3rd day of March, 1953.(Seal) EDWARD IRWIN, 3452l-o Secretary-Treasurer.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, on the 16th of March, 1953, authorized the change of name of \"Le Syndicat National Catholique des Charpentiers Menuisiers, Inc.des Chutes Shawinigan\" into that of \"Syndicat des Charpentiers Menuisiers de Shawinigan Falls\", and such, pursuant to the provisions of section 7 and following of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, this eighteenth day of March, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34522 Acting Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Le Garage Coopératif de Victoriaville\", under date March 25, 1953, whereof the head office is at Victoriaville, in the county of Arthabaska and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of March, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34526 Acting Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the by-law, as adopted on August 20, 1929, bylaw No.1 (Bank Account), as dopted on August 20, 1929, by-law No.2 (documents to be signed), as adopted on August 30, 1929, by-law No.3a, as adopted September 4, 1929, by-law No.4, authorizing the issue of $230,000 of bonds, as adopted on November 23, 1929, by-law No.5, as adopted on March 21, 1930, by-law No.6, as adopted April 11, 1930, by-law No.7, authorizing the issue of $225,000 of bonds, as adopted on May.9, 1930, by-law No.8, authorizing the issue of bonds amounting to $80,000, as dopted on February 13, 1933, by-law No.9, giving an additional guarantee for the bonds amounting to $225,000, as adopted on February 13, 1933, by-law No.11, as adopted on April 15, 1935, by-law No.13, authorizing the issue of bonds for an amount of 338,000, as adopted on June 12, 1939, and the amendment carried by by-law No.1, as adopted on March 27, 1948, of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 4th, 1958, Vol.85, No.14 1173 sion d'obligations pour un montant de $338,000., tel qu'adopté le 12 juin 193!), et l'amendement apporté au règlement N° I, tel qu'adopté le 27 mars 1948, «le ('\"Hospice Saint-Henri Incorporée\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 27 mars 1953.Le Sous-secretaire adjoint de la Province, 34532-0 LUCIEN DARVEAU.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dfment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat .coopératif \"Syndicat Coopératif d'Habitations de Saint Hilaire\", en date du 20 février 1953, dont le siège social est situé à Saint-Hilairc, dans le comté de Rouville, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 17 mars 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34533-0 LUCD3N DARVEAU.\"Hospice Saint-Henri Incorporée\", were approved by the Honourable the Provincial Secretary on March 25, 1953, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of March, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34532 Acting Under-Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif d'Habitations de Saint Hilaire\", under date February 20, 1953, whereof the head office is at Saint-Hilaire, in the county of Rouville and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, on march 17, 1953.LUCIEN DARVEAU, 34533 Acting Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des compagnies minières de Québec) Avis est donné que la compagnie \"Clover Petroleums Ltd.\", autorisée à vendre ou autrement aliéner, dans la province de Québec, ses actions, stocks, certificats d'actions, obligations et autres valeurs, a changé son agent principal, et (pie le nouvel agent principal, aux fins de recevoir les assignations ou procédures exercées contre elle, est M.T.Palmer Howard, avocat, de Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau de Secrétaire de la Province le 31 mars 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34542 LUCIEN DARVEAU.NOTICE (The Quebec Mining Companies Act) Notice is hereby given that the \"Clover Petroleums Ltd\", company has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stock, stock-certificates, debentures and other securities, to change its chief agent, and that » its newly appointed chief agent, for the purpose of receiving service in proceedings against it, is Mr.T.Palmer Howard, advocate, of the town of Mount-ltoyal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Sccretarv, the thirtv-first dav of March, 1953.LUCIEN DARVEAU.Acting Under Secretary 34542 , of the Province.L'hôpital d'Youvillb de Shekbkooke Règlement N° 80 Relatif à l'augmentation du nombre des directrices de la Corporation : 1 ° Le nombre des directrices de la Corporation est, par les présentes, augmenté de trois à cinq, de sorte que le Bureau de direction de la Corporation sera maintenant composé de cinq directrices; 2° Trois directrices constitueront un quorum à toute assemblée du Bureau de direction; 3° Tous règlements, résolutions et procédures de la Corporation antérieurs au présent règlement sont, par les présentes, amendés, modifiés ou revisés de façon à donner effet au présent règlement.Je, soussignée, Sœur Saint-Hector, secrétaire de la Corporation \"L'Hôpital d'Youville de Sherbrooke\", certifie, par les présentes, que le règlement n° 30 ci-haut a été dûment adopté par les directrices de la Corporation lors d'une assemblée tenue le 3 mars 1953 et a été par la suite ratifié à l'unanimité par tous les membres lors d'une assemblée générale spéciale des membres de la Corporation tenue le même jour.En foi de quoi, j'ai signé, (Sceau) 34543-0 Sœur SAINT HECTOR.L'hôpital d'Youville de Shehbhooke By-Law No.30 Relative to the increase of the number of Directors of the Corporation: 1.The number of the Directors of the Corporation is hereby increased from three to five, so that the Board of Directors of the Corporation shall now be composed of five Directors: 2.Three Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors; 3.All by-laws, resolutions and procedures of the Corporation anterior to the present by-law are, by these presents, amended, modified or revised so as to give effect to the present by-law.I, the undersigned, Sister Saint-Hector, Secretary of the Corporation, \"L'Hôpital d'Youville de Sherbrooke,\" certify, by these presents, that above by-law No.30, was duly adopted by the Directors of the Corporation at a meeting held on March 3, 1953 and has since been unanimously ratified by all the members at a special general meeting of the members of the Corporation held on the same day.In Testimony whereof, I have signed, (Seal) 34543 Sœur SAINT HECTOR. 1174 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U avril 1963, Tome 86, N° 1A Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Avis est par les présentes donné que la com- Notice is hereby given that \"Adolphe Studio pagnic \"Adolphe Studio Limitée\" \u2014 \"Adolphe Limitée\" \u2014 \"Adolphe Studio Limited\", a cof- Studio Limited\", une corporation constituée en poration constituted under the Quebec Com- vertu de la Loi des compagnies de Québec, et panics' Act and having its head office in the city ayant son siège social en la cité de Montréal, of Montreal, will apply to the Attorney General s'adressera au Procureur général de la Province of the Province of Quebec for leave to surrender de Québec, pour obtenir la permission d'aban- its charter under the provisons of the Qsebee donner sa charte conformément aux dispositions Companies' Act.de la Loi des compagnies de Québec.Dated at Montreal, this 27th day of January, Daté à Montréal, ce 27e jour de janvier 1953.1953.Le Secrétaire, KURT STEGMEIER, 34524-o KURT STEGMEIER.34524-o Secretary.avis de demande d*acceptation de l*abandon notice of application for surrender d'une Charte of Charter Avis est donné qu'en vertu de la première par- Under the provisions of Part I of the Quebec tie de la Loi des Compagnies de Québec, \"J.- Companies' Act, \"J.-Edmond Côté Limitée\", Edmond Côté Limitée\", s'adressera au Procu- hereby gives notice that it will make application reur Général pour demander l'acceptation de to the Attorney General for acceptance of the l'abandon de sa charte et son annulation à surrender of its charter and its cancellation on ami compter d'une date à être fixée par lui.from a date to be fixed by him.Daté à Jonquière ce lGème jour de mars, 1953.Dated at Jonquière, this 16th day of March, 1953.Par le Président, J.EDMOND COTÉ, 34528-o J.-EDMOND COTÉ.34528-o by Chairman.Robert Berry Co.Ltd.Robert Berrv Co.Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la com- Notice is hereby given that \"Robert Berry Co.pagnic \"Robert Berry Co.Ltd.\" a l'intention de Ltd.\" intends to make application to the Attor- s'adresser au Procureur général de la province ney General of the Province of Quebec for leave de Québec, pour obtenir la permission d'aban- to surrender its Charter for cancellation, donner sa charte aux fins d'annulation.Montréal, P.Q.le 31 mars 1953.Montreal, P.Q., March 31st, 1953.Le Secrétaire, JEAN B.BERRY, 34536 JEAN B.BERRY.34530-o Secretarv.AVIS Avis est par les présentes donné que \"L'Association des Policiers et Pompiers de la Cité de Granby, Inc.\", incorporée suivant la troisième partie de la loi des Compagnies de Québec, s'adressera à l'honorable Procureur Général de la Province de Québec pour lui demander la permission d'abandonner sa charte émise au nom de ladite association le 22ième jour de novembre 1948, et enregistrée le 25 novembre, 1948, libro 219, Folio 154, par le Sous-Registraire de la Province.\u2022 Granby, Que., le 28 mars 1953.L'Association des Policiers et Pompiers de la Cité de Granby, Inc., Par le Procureur, 34546-o GEO.-II.DUREAULT, C.R.NOTICE Notice is hereby given that \"The Association of Policemen and Firemen of the City of Granby, Inc.\", incorporated in virtue of Part three of the Quebec Companies' Act, will apply to the Honorable the Attorney General of the Province of Quebec, for permission to surrender its charter, issued in the name of the Association the '22nd dav of November.1948, and registered the 25th day of November.1948; libro 219.Folio 154.by the assistant registrar of the Province.Granby, Quebec, March 28th, 1953.The Association of Policemen and Firemen of the City of Granby Inc., GEO.-II.DUREAILT, Q.C.34546-0 Solicitor.Département des Affaires municipale Department of Municipal Affairs Annexion a la ville d'Isle Maligne A qui les présentes peuvent concerner: Avis est par les présentes donné que, par l'arrête en conseil N° 377, du 26 mars 1953, et conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi des cités et villes, (S.R.Q.1941, chapitre 233), il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement N° 12 du conseil Annexation to the Town of Isle-Maligne To whom it may concern : Notice is hereby given that by Order in Council No.377, of March 26, 1953, and pursuant to the provisions of section 43 of the cities and towns Act (R.S.9., 1941, chapter 233), the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve By-law No.12 of the Council of the Town of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April J,th, 1953, Vol.85, No.1A 1175
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.