Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 juin 1953, samedi 13 (no 24)
[" Tome 85, N° 24 1955 Vol.85, No.24 \t¦\t \t\tHHI \t¦\t Drapeau de la province de Québec adopté parla Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 13 juin 1953 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1953.Québec, le 8 juin 1953.L'Imprimeur de la Reine.35004-24-12-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June, 13th, 1953 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1953.Quebec, this 8th, of June 1953.REDEMPTI PARADIS, 35004-24-12-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.0270 1956 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° SA insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Heine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite a l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sfont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc: Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre: le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie 3ue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine.REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u2014 1-52 Lettres patentes Anglo-Fiench Carpet Co.Ltd.\u2022» Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRi-chelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze mai 1953, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur Daniel Ruby, Lewis Jack Manolson, comptables sagréés, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning: but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc: First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number: the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion: the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.REDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.- Quebec, June 27th, 1940.33898 \u20141-52 Letters Patent Anglo-French Carpet Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the\" Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2,chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: Milton Lowen Klein, advocate, Arthur Daniel Ruby, Lewis Jack Manolson, chartered accountants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.85, No.21 1957 Exercer le commerce et faire le négoce de toutes sortes de carpettes, tapis, revêtements de planchers et décorations, appareils de radio et de télévision, réfrigérateurs, meubles, vêtements, quincaillerie et dispositifs électriques, sous le nom de \"Anglo-French Carpet Co.Ltd.\", avec un capital de $75,000, divisé en 350 actions privilégiées de $100 chacune et 400 actions ordinaires de $100 chacune.* Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Associated Sales Agency, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit mai 1953, constituant en coq>oration: Joseph Helal, avocat et conseil en loi de la Reine, Samuel Berger, avocat, de la cité de Montréal, Royal Werry, avocat et conseil en loi de la Reine, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements de toute description, nouveautés, bijouterie, papeterie et quincaillerie, sous le nom de \"Associated Sales Agency, Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le hiut mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Au Relais de la Place d'Armes Lu'e Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du premier mai 1953, constituant en corporation: Yves Pratte, avocat, de Sillery, Paul Nor-mandin, étudiant, Paillette Belleau, secrétaire, fille majeure, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme restaurateurs, sous le nom de \"Au Relais de la Place d'Armes Ltée\".Le capital-actions de la compagnie sera divisé en 7,950 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune et 50 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à 16 rue Ste-Anne, en les cité et district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1953.¥\u2022 L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Bern Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la To carry on business and deal in all kinds of carpets, carpeting, floor coverings and decorations, radios, televisions, refrigerators, furniture, clothing, hardware and electrical appliances, under the name of \"Anglo-French Carpet Co.Ltd.\", with a capital stock of $75,000, divided intp 350 preferred shares of $100 each and 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Associated Sales Agency, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of May, 1953, incorporating: Joseph Helal, advocate and Queen's Counsel, Samuel Berger, advocate, of the city of Montreal, Royal Werry, advocate and Queen's Counsel, of the city of Westmount, all in the judicial* district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel of every description, novelties, jewellery, stationery and hardware, under the name of \"Associated-Sales Agency, Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of $100 each and 200 common shares of $100 each.« The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1953.L.DÉSLLETS, 34991 Deputy Attorney General.Au Relais de la Place d'Armes Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: Yves Pratte, advocate, of Sillery, Paul Normandin, student, Paulette Belleau, secretary, spinster, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Au Relais de h Place d'Armes Ltée\", The capital stock of the company is to be divided into 7,950 preferred shares of a par value of $5 each and into 50 common shares having no nominal or par value; The head office of the company will be at 16 Sté.Anne Street in the city and judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this first dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Bern Company Notice is hereby given that under Part I.of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 1958 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° 2L province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du onze mai 1953, constituant en corporation : Philip Meyerovitch, c.r., Hyman Solomon, avocats, Morris Shuter, gérant de Bureau, de la cité de Montréal, et Louis Feigenbaum, avocat, de ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers, distributeurs et agents de menus objets, textiles, vêtements, dispositifs électriques, produits alimentaires, meubles, quincaillerie, bijouterie, bois de construction et produits du bois, articles sanitaires, tabac, leurs produits et accessoires, sous le nom de \"Bern Company\", avec un capital de $100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34491 L.DÉSILETS.Burrowes Aluminum Windows (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, confornu'ment à l'article 2.chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du huit mai 1953, constituant en corporation : Harry Blank, procureur, Raymonde Doyle, secrétaire, fdle majeure, Blanka Gyulai, tencuse de livres, veuve, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de fenêtres et moustiquaires, stores, supports, portes et chassis en aluminium, sous le nom de \"Burrowes Aluminum Windows (Québec) Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1953.L'Assistant-])rocureur général, 34991 L.DÉSILETS.Centaur Electric Contractors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièrc, conformément à l'artjcle 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du huitième jour de mai 1953, constituant en corporation: John William Long, avocat et Conseil en Loi de la Reine, d'Outremont, George Beverly Puddicombe, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount et John Owen Phillips, commis, de la ville Greenfield Park, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces d'électriciens, manufacturiers et poseurs d'installations électriques et aussi pourvoir à leur entretien, sous le nom de \"Centaur Electric Contractors Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: Philip Meyerovitch, Q.C., Hyman Solomon, advocates.Morris Shuter, office manager, of the city of Montreal, and Louis Feigenbaum, advocate, of ville Saint-Laurent, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers, distributors and agents of small wares, textiles, clothing, electrical appliances, food products, furniture, hardware, jewellery, lumber and wood products, sanitary wares, tabacco, products and accessories thereof, under the name of \"Bern Company\", with a capital stock of $100',-000, divided into 5,000 common shares of $10 each, and 5,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 3499l-o Deputy Attorney General.Burrowes Aluminum Windows (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of May, 1953, incorporating: Harry Blank, barrister, Raymonde Doyle, secretary, spinster, Blanka Gyulai, bookkeeper, widow, all of the city and judicial distiict of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in aluminum windows and screens, blinds, brackets, doors, sashes, under the name of \"Burrowes Aluminum Windows (Quebec) Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares having a par value of $100 each, and 100 common shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, « 3499l-o Deputy Attorney General.Centaur Electric Contractors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of May, 1953, incorporating: John William Long, advocate and Queen's Counsel, of Outremont, George Baverly Puddicombe,advocate and|Queen's Counsel, of Westmount, and John Owen Phil-lipps, clerk, of the town of Greenfield Park, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: \u2022 To carry on the business of electricians, manufacturers and installers of electrical construction and to provide maintenance therefor, under the name of \"Centaur Electric Contractors Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of 8100 ceach. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1958, Vol.85, No.2L 1959 Le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Clanbrock Realties Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ërovince de Québec, représenté par M.C.La-.ichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatrième jour de mai 1953, constituant en corporation: John Seymour Newman, administrateur de Montréal-Ouest, Bernard Lortie, gérant de Montréal, George Whelan, avocat, de Montréal-Est, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce d'immeubles de toutes descriptions, sous le nom de \"Clanbrock Realties Co.\", avec un capital de $100,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 - L.DÉSILETS.Columbia International Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du cinquième jour de mai 1953, constituant en corporation: Moshe Ely Bonim, administrateur Raymonde Doyle, June Kirlin, secrétaires, filles majeures, Blanka Gyulai, teneuse de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, faire le commerce et le négoce de machineries, outils, et accessoires, moteurs électriques, radios, pièces et accessoires électronique, sous le nom de \"Columbia International Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Commonwealth Securities Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-quatrième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Moses Moscovitch, Ben Schecter, avocats et Margaret McMartin, fille majeure, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir ou disposer de valeurs, sous le nom de \"Commonwealth Securities Corporation\", The head office of the company will be at the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Clanbrock Realties Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourth day of May, 1953, incorporating: John Newman, executive, of Montreal West, Bernard Lortie, manager of Montreal, George Whclan, advocate, of Montreal East, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with real property of any description, under the name of \"Clanbrock Realties Co.\", with a capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $100 each, and 900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourth dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-o Deputy Attorney General.Columbia International Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifth day of May, 1953, incorporating: Moshe Ely Bonim, executive, Raymonde Doyle, June Kirlin, secretaries, spinsters, Blanka Gyulai, bookkeeper, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with machinery, machinery tools and accessories, engines, motors, electrical apparatus, radios and electronic parts and acessories, under the name of \"Columbia International Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares having a par value of $100 each, and 100 common shares having a par value of $100 each.The head office of the \"company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Commonwealth Securities Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fourth day of April, 1953, incorporating: Moses Moscovitch, Ben Schecter, advocates, and Margaret McMartin, spinster, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire or dispose of securities, under the name of \"Commonwealth Securities Corpora- 1G63 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° 24 avec un capital de $100,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 800 actions privilégiées, série \"A\" d'une valeur au pair de $50 chacune et 400 actions privilégiées, série \"B\" d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-quatrième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Decastclneau Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du deux mai 1953, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi de la Reine, Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, de Montréal, Theodore H.Shapiro, avocat, de.Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Decastelneau Corp.\" avec un capital de $40,000, divisé en 30 actions ordinaires de $100 chacune, 200 actions privilégiées de $100 chacune et 170 actions catégorie A sans droit de vote d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Eastern Insurance Agencies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Philip Meyerovitch, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Morris Shuter, gérant de bureau, tous deux de la cité de Montréal, Louis Feigenbaum avocat, de ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants.Exercer les affaires de courtiers d'assurance et agir comme agents d'assurance, sous le nom de \"Eastern Insurance Agencies Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lei siège social de la compagnie sera à 660 ouest, rue Ste-Catherine, chambre 805, en les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai-'1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Eastern Smelting and Refining Company Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a tion\", with a capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each, 800 Class \"A\" preferred shares of the par value of $50 each and 400 Class \"B\" preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 3499l-o Deputy Attorney General.Decastelneau Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Govrenor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the second day of May, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queen's Counsel, Erhcl Yusscm, secie-tary, spinster of Montreal, Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount-Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: ' To acquire and deal with a certain immoveable property, under the name of \"Decastelneau Corp.\", with a capital stock of 840,000 divided into 30 common shares of $100 each, 200 preferred shares of $100 each and 170 Class A non-voting shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Eastern Insurance Agencies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Philip Meyerovitch, advocate and Queen's Counsel, Morris Shuter, office manager, both of the city of Montreal, Louis Feigenbaum, advocate, of ville St.Laurent, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, and to act as insurance agents, under the name of \"Eastern Insurance Agencies Inc.\", with a.capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of the par value of $10 each, and 1,500 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at 660 St.Catherine Street; West, Room 805, in the city and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of Mav, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Eastern Smelting and Refining Company Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Provisions of the Quebec Mining Companies' Act, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.85, No.24 1961 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du sixième jour de mai 1953, constituant en corporation: Antoine Gobcil, Jean Rivard, avocats, Jacques Jolicceur, comptable, Charles Tremblay, étudiant, Pierre Gagnon, Harry Quart, marchands, et Denise Villeneuve, secrétaire, « tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Eastern Smelting and Refining Company Limited\"' (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de 35,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Emile Lefrançois & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie do la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.I.a-Richelièrç, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1933, constituant en corporation: J.-Émile Lefrançcis, contracteur-plombier, Dame Anne-Marie Coté Lefrançcis, ménagère, épouse séparée de biens dudit J.-Emile Lefrançois, R'iand Lefrançois, ferblantier et plombier, tous de Jonquière, district judiciaire de Chicou-timi, pour les objets suivants: Agir comme maîtres-plombiers, sous le nom de \"Emile Lefrançois & Fils Limitée\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 560, rue Saint-Dominique, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.letter patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixth day of May, 1953, incorporating: Antoine Gobeil, Jean Rivard, lawyers, Jacques Jolieoeur, accountant, Charles Tremblay, student, Pierre Gagnon, Harry Quart, merchants, and Denise Villeneuve, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Eastern Smelting and Refining Company Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $5,000,000, divided jnto 5,000,000 \u2022shares of $1 each.The shareholders shall incur no persnal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares; The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Emile Lefrançois & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: J.Emile Lefrançois, contractor-plumber.Dame Anne-Marie Côté Lefrançois, housewife, wife separate as to prop-perty of the said J.Emile Lefrançois, Roland Lefrançois, tinsmith and plumber, all of Jonquière, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To operate as master-plumber, under the name of \"Emile Lefrançois & Fils Limitée\", with a capital sock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 560 Saint-Dominique Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Fielding Ave.Apts Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.La-.ichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du huitième jour de mai 1953, constituant en corporation : Samuel Godinsky, avocat, de West-mount, Blanka Gyulai, teneuse de livres, June Kirlin, secrétaire, fille majeure, toutes deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce d'immeubles ou d'intérêts en iceux, sous le nom de \"Fielding Ave Apts Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Fielding Ave.Apts Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighth day of May, 1953, incorporating: Samuel Godinsky, advocate, of Westmount, Blanka Gyulai, bookkeeper, June Kirlin, secretary, spinster, both of Montreal, all in the judicial district of Montreal, .for the following purposes: To acquire and deal with real estate or interests therein, under the name of \"Fielding Ave; Apts Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares having a par value of $100 each, and 100 common shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 1962 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1053, Tome 85, N° 24 Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 31991 L.DÉSILETS.C.Bclislc Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour d'avril 1953.constituant en corporation: Paid Gait Michaud, Maurice Mercier, avocats.Thésèse Servant, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"G.Helisle Limitée\".Le capital-actions de la compagnie sera divisé en 400 actions ordinaires sans valeur au pair et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Guy Towers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatrième jour de mai 1953, constituant en corporation: Neil Franklin Phillips, avocat, de la cité de Westmount, Jack Lightstone, avocat, Gertrude Stalport, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et exploiter une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Guy Towers Inc.\", Le montant du capital-actions de la compagnie doit être divisé en 3,000 actions sans valeur nominale ou au pair et 600 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Hadrill & Bruce Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la grovince de Québec, représenté par M.C.La-ichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Raphael Maurice Phillips, ingénieur, Shirley Greenfield, secrétaire, et Samuel J.Smiley, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fleuristes, pépiniéristes, jardiniers-maraîchers, fructiculteurs et grainetiers, sous le nom de \"Hadrill & Bruce Inc.\", avec un capital de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Dated at the office of the Attorney General this eighth dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.G.Belisle Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-ninth dav of Api il, 1953, incoqiorating: Paul Gait Michaun, Maurice Mercier, advocates, Thérèse Servant, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general builders and contractors, under the name of \"G.Bclislc Limitée\", The capital stock of the company shall be constituted of 400 common shares without par value and 400 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Guy Towers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourth day of May, 1953, incorporating: Neil Franklin Phillips, advocate, of the city of Westmount, Jack Lights-tone, advocate, Gertrude Stalport, secretary, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with a certain immoveable property, under the name of \"Guy Towers Inc.\", The amount of the capital stock of the company is to be divided into 3,000 shares having no nominal or par value and into 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attornev General this fourth day of May, 1953.L.DÉSILETS.34991-0 Deputy Attorney General.Hadrill & Bruce Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Raphael Maurice Phillips, engineer, Shirley Greenfield, secretary, and Samuel J.Smiley, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of florists, nurserymen, market gardeners, fruit growers and seedsmen, under the name of \"Hadrill & Bruce Inc.\", with a capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June ISth, 1963, Vol 85, No.24 1963 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième-jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.I.ArshinofT & Son Inc.* Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du onzième jour de mai 1953, constituant en corporation: Charles Wolfson, avocat, Ann Zif-kin, sténographe, fille majeure, Alva Phyllis Boyd, sténographe, fille majeure, de la cité de Montréal, Aaron Hyman Mettarlin, notaire, dé la cité d'Outremont.tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bouchers, sous le nom de \"L Arshinoff & Son Inc.\", avec un capital de $40,000.divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.J.-A.Tremblay & Fils, (Inc.) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patentes, en date du sept mai 1953, constituant en corporation: Fleur-Ange Lortie Tremblay, épouse contrac-tuellement séparée de biens de J.-A.Tremblay, Rolland Tremblay, plombier-électricien, Paul-André Tremblay, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires cemme entrepreneurs en électricité cl en toute entreprise pouvant se rapporter à la transformation et à l'emploi de l'électricité, sous le ncm de \"J.-A.Tremblay & Fils, (Inc.)\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 acti ns de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.J.Eymard Rondeau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément h l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du trente avril 1953, constituant en corporation: Y von Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme commerçants et marchands de mercerie, de vêtements, de nouveautés, d'articles mobiliers, d'accessoires et d'appareils électriques, L ArshinofT & Son Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: Charles Wolfson, advocate, Ann Zifkin, stenographer, spinster, Alva Phyllis Boyd,' stenographer, spinsters, of the city of Montreal, Aaron Hyman Mettarlin, notary of the city of Outremont, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of butchers, under the name of \"I.Arshinoff & Son Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares o£ $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.J.-A.Tremblay & Fils, (Inc.) Notice is hereby given that tinder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Fleur-Ange Lortie Tremblay, wife separate as to marriage contract of J.A.Tremblay, Rolland Tremblay, plumber-electrician, Paul-André Tremblay, accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as contractors in electricity and in any enterprise dealing with the transformation and connected to electricity, under the name of \"J.-A.Tremblay & Fils, (Inc.)\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.J.Eymard Rondeau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter.276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of April, 1953, incorporating: Yvon Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as dealers and merchants in drygoods, clothing, novelties, articles of furniture, electrical aplliances and accessories, agricultural ma- 1964 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1953, Tome 85, N° 24 de machines agricoles et d'instruments aratoires, de matériaux de construction, de denrées et provisions, sous le nom de \"J.Eymard Rondeau Inc.\", avec un capital de $50,000, divisé en 50,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Marie-ville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général le trente avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Jolly Roger Motorcycle Club \u2014 Verdun Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatrième jour de mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Arnold Leggett, apprenti-mécanicien, de Ville Émard, Herbert E.Whittaker, acheteur, Thomas A.Holmes, chimiste, Robert J.Buck, machinist, John A.Eden, assistant, tous quatre de Verdun et Frank J.T.O'Reilly, avocat de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Grouper ensemble ceux qui sont intéressés à se promener et voyager en motocyclette, sous le nom de \"Jolly Roger Motorcycle Club \u2014 Verdun\".Le montant ququel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $25,000.Le siège social de la compagnie sera à 271 avenue Osborne, en la cité de Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.La Cie de Développement Franmont Limitée Franmont Development Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit mai -1953, constituant en corporation: Charles-Auguste Francceur, constructeur, Gil-berte Fontaine, secrétaire, et Yvon Groulx, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire des bâtiments, maisons ou structures diverses comme entrepreneur, sous le nom de \"La Cie de Développement Franmont Limitée\"\u2014\"Franmont Development Co.Limited\", avec un capita! de $20.000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 180 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau .du Procureur général le huit mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-o L.DÉSILETS.La Plomberie Cardinal Incorporée Cardinal Plumbing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a chines and farm implements, building materials, foodstuffs and provisions, under the name of \"J.Eymard Rondeau Inc.\", with a capital stock of $50,000, divided into 50,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Jolly Roger Motorcycle Club \u2014 Verdun .Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichélière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourth day of May, 1953.incorporating without share capital: Robert Arnold Leggett, apprentice machinist, of Ville Émard, Herbert E.Whittaker, purchasing agent, Thomas A.Holmes, chemist, Robert J.Buck machinist, John A.Eden, Helper, all four of Verdun, and Frank J.T.O'Reilly, advocate of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To group together those who are interested in motor-cycle riding and travel, under the name of \"Jolly Roger Motorcycle Club \u2014 Verdun\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $25,000*.The head office of the corporation will be at 271 Osborne Avenue, in the city of Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.La Cie de Développement Franmont Limitée Franmont Development Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of May 1953, incorporating: Charles-Auguste Francceur, builder, Gilberte Fontaine, secretary, and Yvon Groulx, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To erect buildings, houses or various structures, as a contractor, under the name of \"La Cie de Développement Franmont Limitée\"\u2014 \"Franmont Development Co.Limited\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of a par value of $10 each and 180 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the eighth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.La Plomberie Cardinal Incorporée Cardinal Plumbing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.85, No.24 1965 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1953, constituant en corporation: Armand Cardinal, Emilien Pelletier, plombiers, et Pierre Laporte, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: J Faire affaires comme plombiers et comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"La Plomberie Cardinal Incorporée\" \u2014 \"Cardinal Plumbing Inc.\", avec un capital de 810,000, divisé en 750 actions ordinaires de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 3499l-o L.DÉSILETS.La Radio du lias St-Laurent Inc.Lower St.Lawrence Radio Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1953, constituant en corporation: Paul-Êmile (ïagnon, Gilles Gagnon, J.-Claude Gagnon, avocats, tous de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Etablir et opérer une ou des affaires de radiodiffusion, de télévision et de radio-téléphone, sous le nom de \"La Radio du Bas St-Laurent Inc.\"\u2014\"Lower St.Lawrence Radio Inc.\", Le montant du capital-actions de la compagnie sera de 5,000 actions sans valeur nominale et de 5,000 actions privilégiées de la valeur au pair de 820 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit avril 1953.L'Assistant-procureur général, 3499l-o L.DÉSILETS.Le Colisée de Sorel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du premier mai 1953, constituant en corporation: René Thibodeau, marchand, Olivier Beau-dry comptable, Jeanne d'Arc Cournoyer, secrétaire, tous de Sorel.district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Organiser dans les limites de la ville de Sorel, un centre récréatif, sous le nom de \"Le Colisée de Sorel Inc.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 1000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 3.500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnies sera à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: Armand Cardinal, Emilien Pelletier, plumbers, and Pierre Laporte, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as plumbers and as general contractors, under the name of \"La Plomberie Cardinal Incorporée\"\u2014\"Cardinal Plumbing Inc.\", with a capital stock of $10,000, divided into 750 common shares of $10 each and into 250 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.La Radio du Bas St-Laurent Inc.Lower St.Lawrence Radio Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eighth day of April 1953, incorporating: Paul-Emile Gagnon, Gilles Gagnon, J.-Claude Gagnon, advocates, all of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To establish and operate one or many broadcasting, television and radiotclephony concerns, under the name of \"La Radio du Bas St-Laurent Inc.\"\u2014\"Lower St.Lawrence Radio Inc.\", The company's capital stock will amount to 5,000 shares without nominal value and 5,000 preferred shares of a par value of $20 each.The head office of the company shall be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-eighth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Le Colisée de Sorel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May 1953, incorporating: René Thibodeau, merchant, Olivier Beaudry, accountant, Jeanne d'Arc Cournoyer, secretary, all of Sorel, judicial district of Richelieu, for the following purpçses: To organize a recreation centre, within the limits of the town of Sorel, under the name of \"Le Colisée de Sorel Inc.\".The capital stock of the Company is divided into 1000 shares without nominal or par value, and 3,500 preferred shares of $100 each; The head office of the company shall be at Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, the first of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General. 1966 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1968, Tome 86, N° 24 Léo Auger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du deux mai 1953, constituant en corporation: J.-Elzéar Turcotte, marchand, de Charlesbourg, J.-Émilien Simard, avocat, de Québec, tous deux du district judiciaire de Québec, et Léo-Étienne Auger, industriel, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et vendre toutes sortes d'appareils orthopédiques, sous le nom de \"Léo Auger Inc.\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judici-.iire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-o L.DÉSILETS.Le Plâtrage du Québec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du sept mai 1953, constituant en corporation: Antoine (Jobeil, avocat, Denise Villeneuve, secrétaire, célibataire, Jacques Jolicceur, comptable tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations de posage, entretien et réparation de tout enduit intérieur ou extérieur dans la construction, réfection, réparation ou entretien d'immeubles, sous le nom de \"Le Plâtrage du Québec Inc.\", avec un capital de $25,000, divisé en 250 actions.de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 604 rue Saint-Jean, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Léo Auger Inc.^ Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the second day of May 1953, incorporating: J.-Elzéar Turcotte, merchant, of Charlesbourg, J.-Emilien Simard, advocate, of Quebec both of the judicial district of Quebec, and Léo-Etienne Auger, industrialist, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and sell all kinds of orthopedic apparatus, under the name of \"Leo Auger Inc.\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the second day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Le Plâtrage du Québec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Antoine Gobeil, advocate, Denise Villeneuve, secretary, unmarried, Jacques Jolicceur, accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the operations of installation, maintenance and repairs of all interior or exterior coverings in the construction, restauration, reparation or maintenance of immoveables, under the name of \"Le Plâtrage du Québec Inc.\", with a capital steck of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at 604 Saint-John Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General the seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Les Entreprises de Construction et Les Entreprises de Construction et d'Immeuble de Rouville Ltée d'Immeuble de Rouville Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the êrovinçe de Québec, représenté par M.C.La- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifth day of du cinq mai 1953, constituant en corporation: May 1953, incorporating: Paul Langlois, sales-Paul Langlois, vendeur, Frank O'Reilly, avocat, man, Frank O'Reilly, advocate, J.-Claude Nolin, J.-Claude Nolin, avocat, tous des cité et district advocate, all of the city and judicial district of judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Montreal, for the following purposes: Exploiter et faire affaires comme constructeurs To deal in, and carry on a business as builders ct entrepreneurs, sous le nom de \"Les Entre- and contractors, under the name of \"Les Entreprises de Construction et d'Immeuble de Rou- prises de Construction et d'Immeuble de Rouville Ltée\", avec un capital de $100,000, divisé ville Ltée\", with a capital of $100,000, divided en 500 actions privilégiées d'une valeur nomi- into 500 preferred shares of a nominal value of nale de $100 chacune et en 500 actions ordinaires $100 each, and 500 common shares of a nominal d'une valeur nominale de $100 chacune.-value of $100 each.Le siège social de la compagnie est situé à 507, The head office of the company is located at Place d'Armes, Chambre 306, Montréal, dis- 507, Place d'Armes, Room 306, Montreal, judi- trict judiciaire de Montréal.cial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.85, No.24 1967 Daté du bureau du Procureur général le cil mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Les Messageries Interprovinciales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en (late du sept mai 1953, constituant en corporation : Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, Marie-Jeanne Stanton, secrétaire, Léo Davignon, comptable agréé, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'éditeur, sous le nom de \"Les Messageries Interprovinciales Inc.\", avec un capital de $50,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1953.L'Assistant-procureur général, 3499l-o \u2022 L.DÉSILETS.L'Oeuvre des Terrains de Jeux d'Alma Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du douze mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Levasseur, agent d'immeubles, Jean Deschênes, commis, et Louis-Patrick Falardeau, avocat, tous trois de Saint-Joseph-d'Alma, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: \"Organisation des loisirs pour les jeunes, sous le nom de \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux d'Alma\".Le siège social de la corporation sera à Saint-Joseph-d'Alma, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le douze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attornev General, the fiffth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Les Messageries Intcrprovinciales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Gérard Corbeil, advocate of Longueuil, Marie-Jeanne Stanton, secretary, Léo Davignon, chartered accountant, of Montreal, all of the judicial district of Montreal for the following purposes: To carry on the business of editor, under the name of \"Les Messageries Interprovinciales Inc.\", with a capital stock of $50,000, divided into 1,000 shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company wjll be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.L'Oeuvre des Terrains de Jeux d'Alma Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, to incorporate as a corporation without share capital: Paul Levasseur, real estate agent, Jean Deschênes, clerk, and Louis-Patrick Falardeau, advocate, all three of Saint-Joseph-d'Alma, judicial district of Roberval, for the following purposes: The organization of recreational centres for youngsters, under the name of \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux d'Alma\".The head office of the corporation will be at Saint-Joseph d'Alma, judicial district of Roberval Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of Mav, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Louis A.Gaudreau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Louis-A.Gaudreau, agent d'immeubles, Guy Crépeau et Richard Crépeau, avocats, tous trois de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Louis A.Gaudreau Inc.\", avec un capital de.$100,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Louis A.Gaudreau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have \"been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May, 1943, incorporating: Louis-A.Gaudreau, real estate agent, Guy Crépeau, and Richard Crépeau, lawyers, all three of the city of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To acquire and deal with real property, under the name of \"Louis A.Gaudreau Inc.\", with a capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $100 each, and 900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis. 1968 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome S5, N° 24 Daté dubur reau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney Genera' septième jour de mai 1953.this seventh day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 34991 L.DÉSILETS.34991-0 Deputy Attorney General.Machine Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du premier jour de mai 1953, constituant en corporation: Max Kaback, manufacturier, de la cité d'Outreinont, Joseph Kogan, Benn Charles Lassner, tous deux manufacturiers, Edward Samuel Berger, avocat, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter et vendre de la machinerie, matrices, outils et outillage, sous le nom de \"Machine Holdings Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Melrose Packers Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le.Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Lewis Rosenfeld, propriétaire de salaison, Dame Sylvia Silverheart, épouse séparée de biens dudit Lewis Rosenfeld, Harry Rosenfeld, bourgeois, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'emmagasinage et entreposage frigorifique, et celui de mise en conserves et agir comme bouchers, épiciers, marchands et propriétaire d'abattoir * et d'une installation de congélation, sous le nom de \"Melrose Packers Corp.\", avec un capital de $250,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 10,000 actions privilégiées de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 236 est, avenue Mont-Royal, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Melrose Trading Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Èrovince de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du neuvième jour de mai 1953, constituant en corporation: Jean Monette, avocat de Lon-gueuil, Pauline Cabana, sténographe, fille majeure, Rita Angers, sténographe, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Machine Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the first day of May, 1953, incorporating: IN rax Kaback, manufacturer, of the City of Outremont, Joseph Kogan, Benn Charles Lassner, both manufacturers, Edward Samuel Berger, advocate, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To buy and sell machinery, dies, tools and equipment, under the name of \"Machine Holdings Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Melrose Packers Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Lewis Rosenfeld, meat packer, Dame Sylvia Silverheart, wife separate as to property of the said Lewis Rosenfeld, Harry Rosenfeld, gentlemai, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of warehousing and cold storage ami the business of packers, butchers, grocers, produce merchants and abattoir and refrigeration plant proprietors, under the name of \"Melrose Packers Corp.\", with a capital stock of $250,000, divided into 500 common shares of $100 each, and 10,000 preferred shares of $20 each.The head office of the company will be at 236 Mount Royal Avenue, East, Montreal, judicial district of Montreal.\u2022 Dated at the office of the Attorney General this seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Melrose Trading Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformitv with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the ninth day of May 1953, incorporating: Jean Monette, barrister of Longueuil, Pauline Cabana, stenographer, spinster, Rita Angers, stenographer, spinster, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: ' QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol 85, No.24 1969 Diriger et administrer les commerce et affaires de toute compagnie, firme ou individu et relativement à iccux, passer et exécuter de contrats et ententes afin de fournir des services de bureaux et de secrétariat et aussi de procureur des services cléricaux et administratifs, sous le nom de \"Melrose Trading Ltd.\" avec un capital de $40,000, divisé en 30, 000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général.34991 L.DÉSILETS.Modem Plumbing & Heating Ltd.Plomberie et Chauffage Mcdernes Ltées Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du sept mai 19,53, constituant en corporation : Omer Mailloux, Emmanuel Leclerc, plombiers, André Deschambault, commis, Rolande Houle Mailloux, épeuse séparée de biens dudit Omer Mailloux, ménagère, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux, mécaniciens, forgerons et exercer le commerce de plombiers, de couvreurs, de systèmes et d'accessoires de chauffage, sous le nom de \"Modem Plumbing & Heating Ltd.\"\u2014\"Plomberie et chauffage Modernes Ltée\", avec un capital de $75,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.' Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, distrist judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.New Rector's Incorporated Avis est denné qu'en vertu de la première partie de la Lci des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Jack Rudner, Joseph Mendelson, avocats, Celia Coben, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, Moyna Ermshausen, secrétaire, ménagère, épousç séparée de biens de Heing Ermshausen, du village de Ste-Doro-« thée, tous du district judiciaire dé Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de restaurant, sous le nom de \"New Rector's Incorporated\", avec un capital de $40,000, divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.N.R.Bertrand Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des-compagnies de Québec, il a To manage and administer the business and affairs of any company, firm or individual and in connection therewith to enter into and carry out contracts and agreements to provide offices and secratarial, clerical and administrative services, under the name of \"Melrose Trading Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of the par value of $1 each and 2,000 preferred shares of the par value of $5 each., The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this ninth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Modern Plumbing & Heating Ltd.Plomberie et Chauffage Modernes Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.- C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Omer Mailloux, Emmanuel Leclerc, plumbers, André Deschambault, clerk, Rolande Houle Mailloux, wife separate as to property of the said Omer Mailloux, housewife, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To operate as general contractors, mechanics, blacksmiths, and to carry on the business of plumbers, roofers and to deal in heating systems and appliances under the name of \"Modern Plumbing & Heating Ltd.\"\u2014\"Plomberie et Chauffage Modernes Ltée\", with a capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.New Rector's Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity, with section 2 chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Jack Rudner, Joseph Mendelson, advocates, Celia Cohen, secretary, spinster, of the city of Montreal, Moyna Ermshausen, secretary, housewife, wife separate as to property of Hcing Ermshausen, of the village of Ste.Dorothée, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurant, under the name of \"New Rector's Incorporated\", with a capital sfock of $40,000 divided into 50 common shares of $100 each, and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial d'strict of Montreal.Dated at the office of Attorney General this seventh dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.N.R.Bertrand Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1970 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1958, Tome 85, N° U été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du sept mai 1953, constituant en corporation: Norbert Bertrand, Roger Bertrand, ferblantiers, de Montréal, Raoul Laporte, comptable public, de Chamhly-Bassin, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, manufacturer, poser et fabriquer tout système d'évacuation ou de ventilation, tout système de chauffage, d'air climatisé et exercer le commerce de ferblanterie, sous le nom de \"N.R.Bertrand Inc.\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social,de la compagnie sera à 8532, 9ième avenue, ville Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS, O.Ducharnie et Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatre mai 1953, constituant en corporation: Olympe Ducharnie manufacturier, Jean-Jacques Ducharme, ébéniste, tous deux de la cité de Montréal, et Gabriel Ducharme, ébéniste de Montréal-Nord, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous genres de meubles, sous le nom de \"O.Ducharme et Fils Limitée\", avec un capital de $125,000, divisé en 25,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 100,000 actions privilégiées d'une valeur de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatre mai 1953.L'Assistant-procureur général, 3499l-o L.DÉSILETS.Office Stationers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du trente avril 1953, constituant en corporation: Albert Turcotte, industriel, de Ville Mont-Royal, Laurin Lapointe, avocat, Jean-V.Martineau, agent, Alice Savage, secrétaire, de Montréal, René Chalifoux, agent, de Ste-Dorothée, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de papeterie, d'accessoires, d'articles et de fournitures de bureau; agir comme imprimeur, sous le nom de \"Office Stationers Ltd.\",avec un capital de $40,000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Norbert Bertrand, Roger Bertrand, tinsmiths, of Montreal, Raoul Laporte, public accountant, of Chambly-Basin, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To purchase, manufacture, install and set-up any exhaust or ventilation system, any heating system, for air conditioning and to carry on the trade of tinsmith, under the name of \"N.R.Bertrand Inc.\", with a capital of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 8532, 9th Avenue town of St-Michel judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the seventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.O.Ducharme et Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day of May 1953, incorporating: 01ymi)e Ducharme, manufacturer, Jean-Jacques Ducharme, cabinet-maker, both of the city of Montreal, and Gabriel Ducharme, cabinet-maker, of Montreal-North, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of furniture, under the name of \"O.Ducharme et Fils Limitée\", with a capital stock of $125,000, divided into 25,000 common shares of a nominal value of $1 each, and 100,000 preferred shares of a value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fourth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Office Stationers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of April, 1953, incorporating: Albert Turcotte, industrialist of the town of Mount Royal, Laurin Lapointe, advocate, Jean V.Martineau, agent, Alice Savage, secretary, of Montreal, René Chalifoux, agent, of Ste-Dorothée, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in stationery, accessories, articles and office supplies; to operate as a printer, under the name of \"Office Stationers Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 2,000 common xhares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at the town of Mount Royal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol 85, No.24 1971 Daté du bureau du Procureur général le trente avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Philbin Hardware Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du huit mai 1953, constituant en corporation: Herménégilde Valiquette, marchand, Lucille Lavigueur-Valiquette, ménagère, épouse dudit Herménégilde Valiquette, tous deux d'Outre-mont, Alexandre Clément, évaluateur, de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quincaillerie, sous le nom de \"Philbin Hardware Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Plomberie Ducharme Inc.Avis est domié qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ërovince de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze mai 1953, constituant en corporation: André Ducharme, plombier.Jeannette Rousseau, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit André Ducharme, tous deux de Montréal, et Ulysse Ducharme, plombier, de ville Saint-Pierre, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux en plomberie, sous le nom de \"Plomberie Ducharme Inc.\", avec un capital de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le onze mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-o L.DÉSILETS.Produits Naps Inc.Naps Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatrième jour de mai 1953, constituant en corporation: Gilles Rouleau, avocat, Maurice Carpentier, commis, Bérangère Vignolas, secrétaire, fille majeure, de Baie Comeau, district judiciaire du Saguenay, pour les objets suivants: Préparer pour le marché et faire le commerce de produits alimentaires, sous le nom de \"Produits Naps Inc.\"\u2014Naps Products Inc.\", avec un capital de $75,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Philbin Hardware Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighth day of May 1953, incorporating: Herménégilde Valiquette, Lucille Lavigueur-Valiquette, housewife, wife of said Herménégilde Valiquette, both of Outremont, Alexandre Clément, appraiser, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the hardware business, under the name of \"Philbin Hardware Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the eighth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Plomberie Ducharme Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: André Ducharme, plumber, Jeannette Rousseau, housewife, wife separate as to property by marriage contract of the said André Ducharme, both of Montreal, and Ulysse Ducharme, plumber, of the town of Saint-Pierre, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on as general contractors in plumbing, under the name of \"Plomberie Ducharme Inc.\", with a capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the eleventh day of September, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Produits Naps Inc.Naps Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourth day of May, 1953, incorporating: Gilles Rouleau, lawyer, Maurice Carpentier, clerck, Bérangère Vignolas, secretary, spinster, of Baie Comeau, in the judicial district of Saguenay, for the following purposes: To prepare for market and to deal in food products, under the name of \"Produits Naps Inc.\"\u2014 \"Naps Products Inc.\", with a capital stock of $75,000, divided into 500 common shares of $100 each, and 250 preferred shares of $100 each. 1972 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1968, Tome 85, N° 24 Le siège social de la compagnie sera à Baie Comeau, district judiciaire du Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Professional Uniform Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du six mai 1953, constituant en corporation: Georges Jolicceur, Arthur Groleau, industriels, et Alphonse Cadieux, rentier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le métier de tailleurs, et de manufacturiers d'uniformes, sous le nom de \"Professional Uniform Company Limited\", avec un capital de 840,000, divisé en 800 actions d'une valeur au pair de 850.chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6448, rue des Érables, dans les cité et district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Saint-Ruth Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatre mai 1953, constituant en corporation: René Duranleau, c.r., avocat, de l'Ile Bigras, Juliette Mailloux, secrétaire, de West-mount, Jacques Viger, commis de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers, agents de manufacturiers, exportateurs et importateurs de tous produits alimentaires, vestimentaires, de toilette et de parfumerie; d'ameublements, de librairie, de photographie, de pharmacie, de quincaillerie, de bijouterie et crhorlogerie: de matériaux de construction, sous le nom de \"Saint-Ruth Inc.\", avec un capital de 810,000, divisé en 100 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatre mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Sanbar Amusements Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du deuxième jour de mai 1953, constituant en corporation: Louis Stoll, James Fisher, gérants, John Michael Schlesinger, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: The head office of the.company will be at Baie Comeau, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General this fourth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 , Deputy Attorney General.Professional Uniform Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of.the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixth-day of May, 1953, incorporating: Georges Jolicceur, Arthur Groleau, industrialists, and Alphonse Cadieux, annuitant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade of tailors and manufacturers of uniforms, under the name of \"Professional Uniform Company Limited\", with a capital stock of 840,000, divided into 800 shares of a par value of 850 each.The head office of the company will be at 6448, Maple Street, in the city and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Saint-Ruth Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day of May 1953, incorporating: René Duranleau, Q.C., advocate, of He Bigras, Juliette Mailloux, secretary, of Westmount, Jacques Viger, clerck, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as brokers, manufacturers' agents, importers and exporters of all food, wearing apparel, toilet and perfume products; furniture re: bookshop, photography, drug-store, hardware, jewellery, clock and watch making installations; building materials, under the name of \"Saint-Ruth Inc.\", with a capital stock of 810,000 divided into 100 shares of 8100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fourth day of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Sanbar Amusements Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-* lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the second day of May, 1953, incorporating: Louis Stoll, James Fisher, managers, John Michael Schlesinger, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June IStk, 1958, Vol.85, No.24 1973 Exercer le commerce comme distributeurs de phonographes, appareils à diffuser de la musique, sous le nom de \"Sanbar Amusements Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Shell Construction Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatrième jour de mai 1953, constituant en corporation: James Dudley Doherty, Howard Roy Doherty, marchands d'acier, Joseph Feld-gaier, comptable, Steve Frank, entrepreneur en électricité, Edward Irving Auerback, avocat, David Caplan, constructeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Diriger et exploiter le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Shell Construction Company\", avec un capital de $40,000, divisé en 240 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3760 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procurer général, ce quatrième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.St-Hubert Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date, du trente avril 1953, constituant en corporation: Jean-Léon Charlebois, c.r., Robert Page, Jean Duchesne, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: De faire affaire comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"St-Hubert Construction Limited\", avec un capital de $100,-000, divisé en 300 actions communes de $100 chacune et en 700 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 333 Craig Est, chambre 204, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.S t-Lambert Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a' été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date To carry on the business of distributors of phonographs, music diffusion machines, under the name of \"Sanbar Amusements Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 3499l-o Deputy Attorney General.Shell Construction Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourth day of May, 1953, incorporating: James Dudley Doherty, Howard Roy Doherty, steel merchants, Joseph Feldgaier, accountant, Steve Frank, electrical contractor, Edward Irving Auerback, advocate, David Caplan, builder, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Shell Construction Company\", with a capital stock of $40,000, divided into 240 common shares of the par value of $10.each, and 3760 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.St-Hubert Construction Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of April, 1953, incorporating8 Jean-Léon Charlebois, Q.C., Robert Page, Jean Duchesne, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate as general contractors and builders, under the name of \"St-Hubert Construction Limited\", with a capital stock of $100,000 divided into 300 common shares of $100 each and into 700 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 333 Craig East, Room 204, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Si-Lambert Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-ninth 1974 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° 24 du vingt-neuvième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Paul Galt Michaud, Maurice Mercier, avocats, Thérèse Servant, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'automobiles, moteurs, engins, machines, carburateurs, accessoires et pièces, ferronnerie, aussi ^exploiter et diriger des garages, sous le nom dë \"St-Lam-bert Automobile Inc.\"; le capital-actions de la compagnie sera composé de 400 actions ordinaires sans valeur au pair et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lambert, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Télévision de Québec Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du seizième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Camil Noël, c.r., Louis Prattë.tous deux avocats, Rosc-Aimée Fleury, comptable, Thérèse Tardif et Thérèse des Rivières, sténographes, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Quebec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'émissions de télévision et/ou de radio, sous le nom de \"Télévision de Québec Limitée\", avec un capital de $50,000, divisé en 10,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à chambre 609, rue Ste-Anne, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Trio Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du sixième jour de mai 1953, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, de la cité d'Outremont, Bernard Diamond, avocat, Larry Smith, comptable, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce de valeurs, lettres de change, diets de commerce, récépissés d'entrepôts; agir comme courtiers d'assurance; acquérir et faire le commerce de propriétés immobilières ou d'intérêts en icelles.^ous le nom de \"Trio Holdings Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.day of April, 1953, incorporating: Paul Gait Michaud, Maurice Mercier, advocates, Thérèse Servant, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles, motors, engines, machines, carburetors, accessories and parts, hardware; to operate and manage garages, under the name of \"St.Lambert Automobile Inc.\"; the capital stock of the Company shall be constituted of 400 common shares without par value and 400 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at St.Lambert, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 3499l-o Deputy Attorney General.Télévision de Québec Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941.bearing date the sixteenth day of April, 1953, incorporating: Camil Noël, Q.C., Louis Pratte, both advocates, Rose-Aimée Fleury, accountant, Thérèse Tardif, and Thérèse des Rivières, stenographers, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of television and/or radio bradcasting, under the name of \"Télévision de Québec Limitée\", with a capital stock of $50,000.divided into 10,000 shares of $5.each.The head office of the company will be at Room 609, St.Anne Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of April.1953.L.DÉSILETS, 3499l-o Deputy Attorney General.Trio Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixth day of May, 1953, incorporating: Louis Orenstein, advocate, of the city of Outremont,.Bernard Diamond, advocate, Larry Smith, accountant, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal in securities, bills of exchange, trade acceptance, warehouse and receipts; to act as insurance brokers; to acquire and deal with immoveable property or interest therein, under the name of \"Trio Holdings Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1963, Vol.86, No.24 1975 West hall Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du onzième jour de mai 1953 constituant en corporation: Louis Diner, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Moses Naphtali Diner, notaire, Bessie McLean, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires de propriétaires et agents d'immeubles, sous le nom de \"Westhall Holdings Inc.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 300 actions sans valeur nominale ou au pair et 150 actions privilégiée» de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS' 5031 Côte de Liesse Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, de» lettres patentes en date du septième jour de mai 1953, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat, c.r., Ethel Yussem, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, et Théodore H.Shapiro, avocat, de ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"5031 Côte de Liesse Corporation\", avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Westhall Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of May, 1953, incorporating: Louis Diner, advocate and Queen's Counsel, Moses Naphtali Diner, notary, Bessie McLean, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate owners and operators, under the name of \"Westhall Holdings Inc.\", The capital stock of the Company is divided into 300 shares having no nomiuaT or par value, and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eleventh day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.5031 Côte de Liesse Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with sccticn 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventh day of May, 1953, incorporating: Joseph Shapiro, advocate, Q.C., Ethel Yusscm, secretary, both of the city of Montreal, and Theodore H.Shapiro, advocate, of the towr.of Mount Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with a certain immoveable property, under the name of \"5031 Côte de Liesse Corporation\", with a capital stock of $20,000.divided into 200 common shares of $100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of May,-1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Lettres paten tes supplémentaires Cartile - Hume Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 16 mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"Cartile, Casey & Hume Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 21 mars 1952, en celui de \"Car-tile-Hume Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 16 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Supplementary Letters Patent Cartile - Hume Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, changing the name of the company \"Cartile, Casey & Hume Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated March 21, 1952, to that of \"Cartile-Hume Limited\".Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General. 1976 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° 24 Ernest Harnois & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté pzr M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du douze mai 1953, à la compagnie \"Ernest Harnois & Fils Limitée\", portant son capital-actions de 812,000 à 8312,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 3,000 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 12 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Ernest Harnois & Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twelfth day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, S.R.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Ernest Harnois & Fils Limitée\", carrying its capital stock from $12,000 to $312,000 the additional capital stock being divided into 3,000 preferred shares,of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, May 12, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Fine Made Garment Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il.a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.La-ichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 mai 1953, à la compagnie \"Fine Made Garment Co.\", augmentant son capital de $10,000 à $50,000: Le capital additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 19 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Fine Made Garment Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Fine Made Garment Co.\", increasing its capital from $10,000 to $50,000: the additional capital being divided into 400 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 19th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.National Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du douze mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"J.A.Duranceau Construction Ltée \u2014 J.A.Duranceau Construction Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 8 août 1951, en celui de \"National Construction Inc.\" Daté du bureau du Procureur général le 12 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.Nesbitt, Thomson and Company, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du onze mai 1953, à la compagnie \"Nesbitt, Thomson and Company, Limited\", réduisant son capital-actions de $2,325,000 à $2,175,000, par l'annulation de 15,000 \"First Preferred Shares\" de $10 chacune, émises et rachetées par la compagnie.Daté du bureau du Procureur général le 11 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.National Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twelfth day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, S.R.Q., 1941, chapter 276, changing the name of the company \"J.A.Duranceau Construction Ltée \u2014 J.A.Duranceau Construction Ltd.\", incorporated by the provisions of Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated August 8, 1951, into that of \"National Construction Inc.\" Dated at the office of the Attorney General, May, 12, 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.Nesbitt, Thomson and Company, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in coniorm-ity with section 2, of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, dated the eleventh of May 1953, to the Company \"Nesbitt, Thomson and Company, Limited\"; reducing its capital stock from $2,325,000 to $2,175,000, by the cancellation of 15,000 \"First Preferred Shares\" of $10 each, issued and redeemed by the Company.Dated at the office of the Attorney General, the 11th of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 18th, 1968, Vol.86, No.U 1977 R.Forget Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièie, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 270, des lettres patentes supp'émentaires, en date du douze mai 1953, à 'a compagnie \"R.Forget Limitée\", portant son capita' de $20,000 à $100,000: »e nouveau capita'-actions étant divisé en 800 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 12 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991-0 L.DÉSILETS.R.Forget Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, dated May twelfth 1953, to the Company \"R.Forget Limitée\", increasing its capital stock from $20,000 to $100,000: the new capital stock Deing divided into 800 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, the 12th of May 1953.L.DÉSILETS, 34991 Deputy Attorney General.The Sherbrooke Motors Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 11 mai 1953, à la compagnie \"The Sherbrooke Motors Limited\", 1° augmentant son capital de $22,000 à $152,000: Le capital-actions additionnel étant divisé en 1300 actions privilégiées de $100 chacune: 2° modifiant les droits, restrictions et privilèges des actions privilégiées déjà existantes.Daté du bureau du Procureur général, le 11 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.The Sherbrooke Motors Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"The Sherbfooke Motors Limited\", 1.increasing its capital from $22,000 to $152,000: the additional capital stock being divided into 1300 preferred shares of $100 each: 2.modifying the rights, restrictions and privileges of the already existing preferred shares.Dated at the office of the Attorney General the 11th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Wm.Malo & Sons Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 12 mai 1953, à la compagnie |\"Wm.Malo & Sons Inc.\", augmentant son caoital de $40,000 à $80,000: Le capita-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 12 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34991 L.DÉSILETS.Arrêtés en Conseil Wm.Malo & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Wm.Malo & Sons Inc.\", increasing its capital from $40,000 to $80,000: the additional capital stock being divided into 400 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 12th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34991-0 Deputy Attorney General.Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 642 Québec, le 29 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"/)\" Concernant un amendement au règlement de prélèvement du Comité paritaire des métiers de la construction des Trois-Rivières.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 642 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"D\" Concerning an amendment of the levy by-law of the Building Trades Joint Committee of Trois-Rivières.Ii is ordained, on the recommendation of the Honourable Prime Minister, 1978 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° 24 Que le règlement de prélèvement du Comité paritaire des métiers de la construction des Trois-Rivières, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 620-.I du 20 mai 1953, soit ameîldé comme suit: 10 lœs mots \"des artisans\" sont ajoutés après les mots \"des employeurs professionnels\", dans l'alinéa \"6\" du deuxième paragraphe.2° 2° Le paragraphe \"c\" suivant est ajouté à l'article 1, intitulé \"Cotisation\": \"c) Les artisans assujettis au décret doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération basée sur le taux de salaire établi par le décret pour le salarié dont ils exercent le métier ou l'occupation.\" 3° Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2, intitulé \"Mcde de perception\": \"Les artisans et les salariés non à l'emploi des employeurs professionnels doivent faire la remise de leur prélèvement, mensuellement, au siège social du Comité paritaire.\" C.LARICHELIÈRE, 35010-o Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 658 Québec, le 29 mai 1953 Présent : Le Lieutcnant-Gou.verneur-en-Conseil.Concernant la pêche dans le Parc de la Gaspésie et la Réserve des Shick-Shocks.Attendu Qu'il existe dans le Parc de la Gaspésie et la Réserve des Shick-Shocks plusieurs beaux lacs et qu'il importe de protéger la faune aquatique dans ces lacs.Vu l'article 65 du chapitre 153 ainsi que l'article 44 du chapitre 156 des Statuts refondus de Québec 1941; Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre de la chasse et des pêcheries: Que la pêche au ver ou à l'appât vivant soit défendue dans les limites du Parc de la Gaspésie et de la Réserve des Shick-Shocks.C.LARICHELIÈRE, 34992-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.That the levy by-law of the Building Trades Joint Committee of Trois-Rivières, approved by Order in Council No.620-J of May 20, 1953, be amended as follows: 1.The word \"artisans\" is added after the words \"professional employers\" in paragraph \"6\" of the second subsection.2.The .following subsection \"c\" is added to section 1 headed \"Assessments\": \"c) The artisans governed by the decree shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% of their remuneration based on the wage rate established in the decree for their trade or occupation.\" 3.The following subsection is added to section 2 headed \"Mode of collection\": \"Artisans and employees not employed by professional employers shall forward their assessment every month to the head office of the Parity Committee.\" C.LARICHELIÈRE, 35010-o Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECFUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 658 Quebec, May 29, 1953.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Concerning fishing in the Gaspésian Park ami Shick-Shocks Reserve.Whereas in the Gaspesian Park and Shick-Shocks Reserve there are beautiful lakes and that it is essential that the aquatic fauna be protected therein.In view of Section 65, Chapter 153, as well as Section 44, Chapter 156 of the Revised Statutes of Quebec, 1941 : It is ordained upon the recommendation of the Honourable the Minister of Game and Fisheries : That fishing with worms or live bait be prohibited within the limits of the Gaspesian Park and Shick-Shocks Reserve.C.LARICHELIÈRE, 34992 Acting Clerk of the Executive Council.Actions en séparation de biens Actions for separation as to property Canada, Province de Québec, District de Canada, Province of Quebec, District of Montréal, Cour Supérieure, N° 334482.Annette Montreal, Superior Court, No.334482.Annette Brunet, de la cité de Verdun, district de Montréal, Brunet, of the city of Verdun, district of Mont-épouse commune en biens de Roger Barré, mar- real, wife common as to property of Roger Barré, chand, des mêmes lieux, demanderesse* vs Roger merchant, of the same place, plaintiff: vs Barré, marchand, des mêmes lieux, défendeur.Roger Barré, merchant, of the same place, defendant.Une action en séparation de biens a été insti- An action for separation as to property was tuée en cette cause le 9ième jour de juin 1953.instituted in this case on the 9th day of June, 1953.Montréal, ce 9ième jour de juin 1953.Montreal, this 9th day of June 1953.Les Procureurs de la demanderesse, BLAIN et DAGENAIS, 35017-o BLAIN et DAGENAIS.35017-o Attorneys for the plaintiff.Province de Québec, District de Montréal, Province of Quebec, District of Montreal, Cour Supérieure, N° 333945.Dame Cécile- Superior Court, No.333945.Dame Cécile-Aline Emery, épouse commune en biens de Aline Emery, wife common as to property of Robert Leclerc, des cité et district de Montréal, Robert Leclerc, of the city and district of Mont-demanderesse- vs ledit Robert Leclerc, défendeur, real, plaintiff: vs the said Robert Leclerc, defendant. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1958, Vol.85, No.24 1979 Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 27e jour de mai 1953.Montréal, 6 juin 1953.Les Procureurs de la demanderesse, 350I8-o BENOIT, BENOIT & BOULANGER.An Action in separation as to property ha8 been instituted in this case on the 27th dav of May, 1953.Montreal, June 6, 1953.BENOIT, BENOIT & BOULANGER, 35018-o Attorneys for Plaintiff.Avis divers Miscellaneous Notices AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Ville Emard Baptist Church\", 6572 Boulevard Monk, Montréal, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, pour obtenir son incorpor.ition en vertu de la Loi de 'a constitution de certaines ég'ises, chapitre 311, Statuts Refondus 1941 et ses amendements.Montréal, le 25 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231, ouest, rue St-Jacques, 34916-22-4 Montréal.AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Emmanuel Baptist Church,\" 350 avenue Woodland, cité de Verdun, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, pour obtenir son incorporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines églises, chapitre 311 des Statuts Refondus de la province de Québec, 1941 et ses amendements.Montréal, le 25 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON, 231 ouest rue St-Jacques, 34915-22-4 Montréal.AVIS PUBLIC Avis est.par les présentes, donné que \"Grace Gospel Chapel\", une des Églises de la \"Christian Bre'then\" de la province de Quebec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, pour obtenir son incorporation; en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus de la province de Québec, 1941 et amendements.Montréal, 30 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231 ouest, rue St-Jacques, Montréal.34968-23-4 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Ville Emard Baptist Chruch,\" 6572 Monk Boulevard, Montreal, will present a Petition to the Lieut.Gover-nor-in-Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941 and Amendments.Montreal, May 25th, 1953.CERINI & JAMIESON, Solicitors for Petitioner, 231, St-James St.West, 34916-22-4-o Montreal.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that \"Emmanuel Baptist Church\", 350 Woodland Avenue, City of Verdun, will present a Petition to the Lieut.Governor-in-Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and Amendments Montreal, May 25th, 1953.CERINI & JAMIESON, Solicitors for Petitioner, 231, St-James St.West, 34915-22-4-0 Montreal.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Grace Gospel Chapel\", one of the Christian Brethren Churches in the Province of Quebec, will present a Petition to the Lieut.-Governor-in-Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941 and Amendments.Montreal, May 30th, 1953.CERINI & JAMIESON, Solicitors for Petitioner.231 St.James St.West, Montréal.34968-23-4-o Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du Syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Desjardins de Guyenne\", en date du là avril 1953, dont le siège social est situé à Saint-Émilc-de-Guyenne, dans le Comté d'Abitibi-Oucst, et ,que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 28 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, 34993-d LUCIEN DARVEAU.Notice \"hs hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire Desjard ns de Guyenne\" under date the thirteenth day f April 1953, whereof the head office is at Sa nt-Emilc-de-Guyennc, in the County of Abitibi-West and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th of May 1953.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 34993 of the Province. 1980 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° U Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 25 mai 1953, les amendements apportés aux articles 13, 5, 15 et 18 du règlement no 1 de \"Le Centre Récréatif de Dorval\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 26 mai 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, 34994-0 LUCIEN DARVEAU.Notice is given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable Provincial Secretary approved, on May 25 1953, the amendments to Articles 13, 5, 15 and 18 of By-Law No.I, of \"Le Centre Récréatif de Dorval\", and such, in conformity with Section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the 26th of May 1953.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 34994 of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat des Employés de Sylvania Electric (Canada) Ltd.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le quatre juin 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Drummondville, dans le comté de Drummond.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34999-0 LUCIEN DARVEAU.La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée Règlement spécial \"A\" (1953) Attendu que la compagnie a discontinué ses opérations, sauf pour les fins de la liquidation: Attendu qu'il a été pourvu au paiement de toutes les dettes et obligations de la compagnie: Il est en conséquence décrété comme règlement de la Compagnie: 1° la dompagnie est autorisée par les présentes à distribuer au pro rata à ses actionnaires la totalité de son actif et subséquemment à adresser au procureur général une demande pour qu'il accepte l'abandon de la charte de la compagnie, ordonne l'annulation de ladite charte et fixe une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute: 2° deux directeurs sont, par les présentes, autorisés à signer tous documents et faire toutes choses qu'ils pourront juger nécessaires aux fins du présent règlement.Copie fidèle du règlement ci-dessus adopté par les directeurs de \"La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée\" le 8ième jour de juin 1953 et approuvé le même jour par les actionnaires.Le Secrétaire, 35008-o PD3RRE DANSEREAU.Nesbitt, Thomson and Company, Limited Règlement dix-sept Pour augmenter le nombre des directeurs de douze à quatorze Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété: 1° Le nombre des directeurs de la compagnie est, par les présentes, augmenté de douze à quatorze.2° Le règlement trois de la compagnie, tel qu'amendé, est, par les présentes, amendé de NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat des Employés de Sylvania Electric (Canada) Ltd.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June fourth, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Drummondville, in the County of Drummond.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 34999 of the Province.La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée Special By4aw \"A\" (1953) Whereas the company has ceased to carry on business, except for the purpose of winding-up its affairs: Whereas the debts and obligations of the company have been provided for: Now therefore be it enacted as a By-law of the Company.1.that the company is hereby authorized to distribute its assets rateably among its shareholders and subsequently to apply to the Attorney General requesting him to accept the surrender of the charter of the company, to direct the cancellation of the said charter and to fix a date upon and from which the company shall be dissolved: 2.any two directors are hereby authorized to sign all documents and do all things which they may consider necessary for the purposes of this by-law.Certified true copy of the above by-law of \"La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée\" enacted by the directors on June 8th, 1953 and approved by the shareholders the same day.PIERRE DANSEREAU, 35008-o Secretary.Nesbitt, Thomson and Company, Limited By-law Seventeen To increase the number of Directors from twelve to fourteen Be it and it is hereby enacted that: 1.The number of the Directors of the Company is hereby increased from twelve to fourteen.2.By-law three of the Company, as amended is hereby further amended by deleting the word QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June ISth, 1953, Vol.86, No.*4 1981 nouveau en rayant les motjet chiffre \"douze (12)\" of) il apparait à l'article 1 et en y substituant les mot et chiffre \"quatorze (14)\".Certifié vraie copie du règlement dix-sept de la compagnie Nesbitt, Thomson and Company, Limited décrété à une assemblée des directeurs de ladite compagnie tenue le 20 avril 1953, et approuvé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentées en personne ou par procuration à une assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite compagnie dûment convoquée et tenue, le 25 mai 1953, dans le but de considérer ledit règlement dix-sept.Montréal, P.Q., 25 mai 1953.(Sceau) L'Assistant-secrétaire, 35009 H.S.DUNN.Montreal Motors Ltd.Règlement N° $9 Que le règlement N° 10 des Règlements généraux de la Compagnie soit amendé et que le nombre des Directeurs de la Compagnie soit porté de trois à quatre.Montréal, ce 28 mai 1953.Certifié copie conforme.Le Secrétaire, 35014-o J.DUPRÉ.Princess Silks Inc.Règlement spécial N° 23 Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de Princess Silks Inc., que le nombre des directeurs soit, et il est, par les présentes, augmenté de trois (3) à quatre (4).Certifié vraie copie du règlement spécial N° 23 passé à une assemblée générale spéciale des actionnaires de \"Princess Silks Inc.\", à Montréal, le 19 mai 1953.(Signé) Le Secrétaire, 35015 Mme ANNE ABRACEN.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat Régional des Institutrices de Mont-Joli\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-cinq mai 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Mont-Joli, dans le district judiciaire de Rimouski.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 35023-o LUCD3N DARVEAU.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative Charlemagne\", en date du 24 mai 1953, dont le siège social est situé à Charlemagne, dans le comté de L'Assomption, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 1er juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint ce la Province, 35027-o LUCIEN DARVEAU.and figure \"twelve (12)\" where they appear in article 1 thereof and substituting therefor the word and figure \"fourteen (14)\".Certified to be a true copy of By-law seventeen of Nesbitt, Thomson and Company, Limited, enacted at a meeting of Directors of said Company held on April 20th, 1953, and approved by the vote in person or by proxy at a Special General Meeting of the Shareholders of said Company duly called and held for the purpose of considering said By-law Seventeen, on May 25th, 1953.Montreal, P.Q., May 25th, 1953.(Seal) H.S.DUNN, 35009-o Assistant-Secretary.Montreal Motors Ltd.By-law No.29 That by-law No.10 of the General By-laws of the Company be amended and that the number of Directors of the Company be carried from three to four.Montreal, this 28th day of May, 1953.Certified true copy.J.DUPRÉ, 35014 Secretary.Princess Silks Inc.Special By-Law No.28 Be it enacted, and it is hereby enacted as a By-Law of Princess Silks Inc., that the number of the Board of Directors be, and it is hereby increased from three (3) to four (4).Certified true copy of Special By-Law No.23 passed at Special General Meeting of Shareholders of \"Princess Silks Inc.!', at Montreal, oh May 19th, 1953.(sgd) Mrs.ANNE ABRACEN, 35015-o Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat Régional des Instititrices de Mont-Joli\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May twenty-fifth 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Mont-Joli, in the judicial district of Rimouski.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 35023 of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Coopérative Charlemagne\" under date the twenty-fourth day of May 1953, whereof the head office is at Charlemagne, in the county of L'Assomption and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this June 1st., 1953.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 35027 of the Province. 1982 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 85, N° 2Jt AVIS (Loi «les syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat des Producteurs de pommes de terre de la région de Nicolet\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le quatre juin 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Nicolet, dans le comté de Nicolet.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 35028-o LUCIEN DARVEAU.Chartes \u2014 Abandon de Piediio Investments Limited Avis ed l'intention d'abandonner sa charte.Avis est donné que la compagnie Piedro Investments Limited, constituée en corporation par lettres patentes de Quel ea datées du 5 nu i 1936, et ayant son siège social en la cité de Montréal, demandera bientôt au Procureur général et au Ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce, province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 14 mai 1953.* Le Procureur de la compagnie, 35019 WALTER S.JOHNSON, C.R.Ruth Gordon Gowns Inc.\u2014 «* Avis est donné que la compagnie \"Ruth Gordon Gowns Inc.\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce lOième jour de juin 1953.Les Procureurs de Ruth Gordon Gowns Inc., 35030 BRODERICK & McQUILLAN.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat des Producteurs de pommes de terre de la Région de Nicolet\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June fourth, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Nicolet, in the county of Nicolet.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 35028 of the Province.Charters \u2014 Surrender of Piedro Investments Limited Notice of intention to surrender charter Notice is hereby given that Piedro Investments, Limited, incorporated by Quebec Letters Patent dated May 5, 1936, and having its head office in the City of Montreal, will shortly apply to the Hon.the Attorney-General and the Hon.Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, Province of Quebec, for permission to surrender its Charter.Montréal, May 14, 1953.\u2022 WALTER S.JOHNSON, Q.C., 35019-o Solicitor of the Company.Ruth Gordon Gowns Inc.Notice is hereby given that \"Ruth Gordon Gowns Inc., a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 10th day of June 1953.BRODERICK & McQUILLAN, Attorneys for 35030-o Ruth Gordon Gowns Inc.Compagnies autorisées à faire des affaires Avis est donné que la compagnie \"Chicago Vocational Training Corporation Ltd.\" a été dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et la compagnie sera sujette aux mêmes formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.Le bureau principal de la corporation dans la Province sera à 65 ouest, rue Jean Talon, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal dans la Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute pour- Companies Licensed to do Business Notice is hereby given that the company \"Chicago Vocational Training Corporation Ltd.\" has been duly licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and the Company shall be subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The principal office of the Corporation in the Province to be at 65 Jean Talon St.W., in the City and Judicial District of Montreal.Its chief agent in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.85, No.24 1983 suite ou procedure prise contre elle, est M.A.Warren Case, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 9ième jour de juin 1953.\u2022 Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34991 LUCIEN DARVEAU.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Eastern Machine Products Limited a été dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et la compagnie sera sujette aux mêmes formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.Le bureau principal de la corporation dans la Province sera à chemin Côte de Liesse, St-Laurent, dans le district judiciaire de Montréal.Son agent principal dans la Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure intentées contre elle, est M.W.-H.Laidlcy, 2000 édifice Aldred, 507 Place d'Armes, en la cité de Montréal.Donné au-bureau du Secrétaire de la Province, ce 9e jour de juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 34991 LUCIEN DARV-EAU.taken against it is Mr.A.Warren Case, of the said City of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of June, 1953.LUCIEN DARVEAU, Acting Under-Secretary 3499l-o of the Province.Notice is hereby given that the company \"Eastern Machine Products Limited\" has been duly licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred upon the said Company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and the Company shall be subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The principal office of the Corporation in the Province to be at Côte de Liesse Road, St.Laurent, in the Judicial District of Montreal.Its chief agent in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding taken against it is Mr.W.H.Laidley, 2000 Aldred Buidling, 507 Place d'Armes, in the City of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th daj of June, 1953.LUCIEN DARVEAU, Acting Under-Secretary 34991-0 of the Province.Curatelle publique Canada, Province de Québec, District de Montréal.Succession vacante de Damien Bertrand.En son vivant de Montréal.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 8 septembre 1952, par un juge de la cour supérieure siégeant à Montréal dans le district de Montréal, qu'il est, sous l'autorité de la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra à l'adresse ci-dessous, dans les quinze jours suivant le 13 juin 1953, le paiement de toutes dettes envers la succession et la preuve de toutes les réclamations exigibles contre elle LE CURATEUR PUBLIC.187, rue Sainte-Catherine (Ouest), Montréal 18.- 34995-0 Public jCuratorship Canada, Province of Quebec District of Montreal.Vacant Estate of Damien Bertrand.In his lifetime of Montreal.The undersigned hereby gives notice that this estate has been declared vacant in virtue of a judgement rendered September 8 1952, by a Judge of the Superior Court sitting at Montreal in the district of Montreal, that he is, under authority of the Public Curatorship (Act 9 Geo.VI ch.62), curator ex officio to said estate, and that he will receive at the address mentioned below, within fifteen days following the 13th of June 1953, payment of all debts owing to said estate, and proof of all claims against it.PUBLIC CURATOR.187 St.Catherine Street, West, Montreal, 18.34995 Département des Affaires municipale Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 4 mai 1953 du conseil municipal de la paroisse de St-Elzéar de Laval, comté de Laval, et conformément aux aispositions de l'article 130 du Code municipal, il a été décrété, en date du 5 juin 1953, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se feront, à l'avenir, dans la Tangue française seulement.Le présent avis est publié en conformité de l'article 131 du Code municipal.(10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 5 juin 1953.Le Sous-ministre des Affaires municipales, 35001-o JEAN-LOUIS DOUCET, C.R.Department of Municipal Affairs The undersigned hereby gives notice that, as requested by a resolution dated May 4, 1953, of the Municipal Council of the parish of St-Elzéar de Laval, county of Laval, ano in conformity with the provisions of Article 130 of the Municipal Code, he has authorized, under date of June 5th, 1953, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, with the exception of those required in the Quebec Official Gazette, shall henceforth be in the French language only.The present notice is published in conformity with Article 131 of the Municipal Code.(10 George VI, Chapter 55, Section 2).Quebec, June 5, 1953.JEAN-LOUIS DOUCET, Q.C., 35001 Deputy Minister of Municipal Affairs. 1984 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1953, Tome 86, N° U Département de l'Agriculture AVIS (Loi des syndicats d'élevage) AvL est donné qu'un syndicat d'élevage a été constitué dans le comté de Rimouski sous le nom de \"Syndicat d'élevage de moutons demi-sang du comté de Rimouski\" avec siège social à Bic.Daté du bureau du ministre de l'agriculture, ce 1er juin 1953.Le Sous-ministre de l'agriculture, 35000-o RENÉ TRÉPANIER.Département de l'Instruction publique Department of Agriculture NOTICE (Stock-Breeding Syndicates Act) Notice is hereby given that a stock-breeding syndicate has been formed in the county of Rimouski under the name of \"Syndicat d'élevage de moutons demi-sang du comté de Rimouski\" with head office at Bic.Dated at the office of the Minister of Agriculture, this first day of June, 1953.RENÉ TRÉPANIER.35000 Deputy Minister of Agriculture.Department of Education N° 557-53.Québec, le 3 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 29 mai 1953, de changer le nom de la municipalité scolaire de Côte Notre-Dàme-de-Liesse, dans le comté de Jacques-Cartier, en celui de ' 'Notre-Dame-de-Liesse\".Cet arrêté ministériel prendra effet huit jours après la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35003-o O.J.DESAULNIERS.N° 205-53.Québec, le 3 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 29 mai 1953, que le territoire de la municipalité scolaire de Ste-Jeanne-d'Arc-d'Almaville, de la municipalité scolaire de la Paroisse d'Almaville et de la municipalité scolaire du village d'Almaville, tous dans le comté de St-Maurice, soit annexé, en vue de former une nouvelle municipalité scolaire distincte sous le nom de Village de Shawinigan-Sud, même comté, ce territoire correspond, en même temp3, au territoire du village de Shawinigan-Sud, tel que décrit dans l'article 1 de la loi 1-2, Elizabeth II, chapitre 105.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35003-o O.J.DESAULND3RS.N° 1420-51.Québec, le 4 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 29 mai 1953, de détacher de là municipalité scolaire de Ste-Gertrude, dans le comté de Nicolet, les lots 571 à 582 du rang XVI (16), du canton de Maddington, et de les annexer à la municipalité scolaire de Ste-Marie-de-Blandford, même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35003-o O.J.DESAULNIERS.N° 321-53.Québec, le 3 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 29 mai 1953, de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Thérèse Ouest, dans le comté de No.557-53.Quebec, June 3, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Ordre in Council dated May 29, 1953, to change the name of the school municipality of \"Côte Notre-Dame-de-Liesse\" in the county of Jacques-Cartier, into that of \"Notre-Dame-de-Liesse\".This Order in Council will come into effect eight days after the publication of the present notice in the Quebec Official Gazette.O.J.DESAULNIERS, 35003 Superintendant of Education.No.205-53.Quebec, June 3, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has, by Order in Council dated May 29, 1953, been pleased to annex the territory of the school municipality of Ste-Jeanne-d'Arc-d'Almaville, of the School municipality of the parish of Almaville and of the school municipality of the Village of Almaville, all in the county of St-Maurice, with a view of forming a new separate school municipality under the name of Village of Shawinigan-South, same county, this territory corresponds, àt the same time, to the territory of the Village of Shawinigan-South, as described in Section 1, of Act 1-2, Elizabeth n, chapter 105.This Order in Council will come into effect the first day of July, 1953.O.J.DESAULNIERS, 35003 Superintendent of Education.No.1420-51.Quebec, June 4, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has, by Order in Council dated May 29, 1953, been pleased to detach from the School Municipality of Ste-Gertrude, in the county of Nicolet, lots 571 to 582 of Range XVI (16) of the township of Maddington, and to annex them to the school municipality of Ste-Marie-de-Blandford, same county.This Order in Council will come into effect the first day of July, 1953.O.J.DESAULNIERS, 35003 Superintendent of Education.No.321-53 Quebec, June 3, 1953.His Honours, the Lieutenant-Governor in Council has, by Order in Council dated May 29, 1953, been pleased to detach from the school municipality of Ste-Thérèse Ouest, in the county QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 18th, 1968, Vol.86, No.24 1985 Terrebonne, les lots du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, portant les numéros suivants, savoir: les lots originaires numéros 80 et 81 et toutes leurs subdivisions présentes et à venir, pour les annexer à la municipalité scolaire de la ville de Ste-Thérèse, même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.- Le Surintendant de l'Instruction publique, 35003-o O.J.DESAULNIERS.N° 597-53.Québec, le 4 juin 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Bristol, dans le comté de Pon-tiac, et d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, à la municipalité scolaire protestante d'Onslow, même comté, le territoire décrit ci-dessous, savoir: Les lots suivants du canton de Bristol, dans les ranjis V, VI et VIT (5, 6 et 7), situés à l'est du N° 13 (le lot N° 13 exclu moins aussi les parties des lots 14, 15 et 16, situés au nord de la tivière Quyon): dans le rang VIH (8), cette partie du lot 17-a, située au sud de la rivière Quyon: dans le rang IV (4), les lots 14-b, 15-c,16-b,17-b, 17-c et 18 à 26 inclusivement: dans le rang III (3), les lots 25 à 27 inclusivement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35005-24-2-o O.J.DESAULND3RS.N° 1452-51 Québec, le 9 juin 1953.Demande est faite que le nom de la municipalité scolaire du village de Rouyn, dans le comté de Rouyn-Noranda, soit changé en celui de \"La municipalité scolaire catholique de Rouyn\".Le Surintendant de l'Instruction publique, 35024-24-2-o O.J.DESAULNIERS.of Terrebonne, lots of the official cadastre for the parish of Ste-Thérèse-de-Blainville, bearing the following numbers, to wit: original lots numbers 80 and 81, and all their present and future subdivisions, to annex them to the school municipality of the town of Ste-Thérèse, same county.This Order in Council will come into effect the first day of July, 1953.0.J.DESAULNIERS, 35003 Superintendent of Education.No.597-53.Quebec, June 4th, 1953.Application is made to detach from the school municipality of Bristol, in the county of Pontiac, and to annex, for the Protestant taxpayers only, to the Protestant School Municipality of Onslow, same county, the territory described herein-under, to wit: The following lots of Bristol Township, in ranges V, VI and VII (5, 6 and 7), situate east of No.13 (Lot No.13 excluded, less also parts of lots 14, 15 and 16, situate north of the Quyon River): in range VIII (8), that part of lot 17-a, situate south of the Quyon River: in range IV (4), lots 14-b, 15-c, 16-b, 17-b, 17-c and 18 to 26 inclusively: in range III (3) lots 25 to 27 inclusively.O.J.DESAULNLERS, 35005-24-o Superintendent of Education.No.1452-51 Quebec, June 9, 1953.Application is made that the name of the School Municipality of the Village of Rouyn, in the county of Rouyn-Noranda, be changed into that of \"The Catholic School Municipalit of Rouyn\".O.J.DESAULND3RS, 35024-24-2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foy division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 131-8 et une partie du lot 131-9 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 23 avril 1953.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre-adj., 35002-o J.-E.GUAY.AVIS Cadastre officiel revisé de la paroisse de Ste-Victoire (canton d'Arthabaska) partie de la municipalité de la ville de Victoriaville\u2014division d'enregistrement d'Arthabaska.Avis est par la présente donné que les lots 255-1, 255-2 et 254-2 sont corrigés et le lot 255-4 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 30 mai 1953.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre-adj., 35002-o J.-E.GUAY Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the parish of Ste-Foy registration divison of Québec.Notice is hereby given that lot 131-8 and part of lot 131-9 are cancelled in virtue of article 2174A of the civil Code.Quebec, April the 23rd, 1953.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-E.GUAY, 35002-o Asst.-Deputy Minister.NOTICE Official revised cadastre of the parish of Ste.Victoire (township of Arthabaska) part of the municipality of the town of Victoriaville\u2014 registration division of Arthabaska.Notice is hereby given that lots 255-1, 255-2 and 254-2 are corrected and lot 255-4 is added in virtue of article 2174A of the civil Code.Quebec, May the 30th, 1953.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-E.GUAY, 35002-o Asst.Deputy-Minister. / 1986 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1953, Tome 86, N° U Département du Travail Department of Labour AVIS DE MODIFICATION NOTICE OF AMENDMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, the Minis-Travail, donne avis par les présentes, conformé- ter of Labour, hereby gives notice, pursuant to ment aux dispositions de la Loi de la convention the provisions of the Collective Agreement Act collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amende- (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments) ments), qu'il se propose de recommander l'appro- that he intends to recommend the approval of bation de la modification suivante au décret nu- the following amendment to the dec.ee No.758 méro 758 du 19 juillet 1951, relatif à l'industrie of July 1951, relating to the paper box industry de la boîte de carton dans la région de Québec.in the district of Quebec.L'article XI sera remplacé par le suivant: Section XI will be replaced by the following: \"XL Salariés des métiers de l'imprimerie: Les \"XL Employees of the printing trades: The conditions de salaires, de travail, d'apprentissage wages labour and apprenticeship conditions of ties salariés des métiers de l'imprimerie régis par the employees of the printing trades working in le décret, sont les mêmes que celles déterminées establishments governed by the decree are those dans le décret numéro 141 du 8 février 1951, mentioned in the decree number 141 of February relatif aux métiers de l'imprimerie dans la région 8, 1951, relating to the printing trades in the de Québec, et ses amendements, ou dans tout district of Quebec as amended, or in any other autre décret qui pourrait le remplacer, à l'excep- decree that could replace it with the exception, tion, toutefois, de la durée régulière de travail however, of the duration of working hours which qui doit être de quarante-cinq (45) heures par shall consist of forty-five (45) hours per week.\" semaine.\" Durant les trente jours à compter de la date During the thirty days following the date of de publication de cet avis dans la Gazette officielle publication of this notice in the Quebec Official de Québec, l'honorable Ministre du Travail rece- Gazette, the Honourable Minister of Labour will vra les objections que les intéressés pourront consider the objections which the interested désirer formuler.parties may wish to set forth.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 13 juin 1953.35010-o Quebec, June 13, 1953.35010-o AVIS DE MODIFICATION NOTICE OF AMENDMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister of Travail, donne avis par les présentes, conformé- Labour, hereby gives notice, pursuant to the ment aux dispositions de la Loi de la convention provisions of the Collective Agreement Act collective (S.R.Q., 1951, chapitre 163 et amende- (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), ments), que le Comité paritaire des barbiers, that the Parity Committee of Barbers, Male and coiffeurs et coiffeuses des Trois-Rivières et dis- Female Hairdressers of the District of Trois- trict lui a présenté une requête à l'effet de modifier Rivières has submitted to him a petition to amend la section \"B\" du décret numéro 1040 du 4 août part \"B\" of the decree No.1040 of August 4, 1948, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et 1948, relating to the barber and hairdresser coiffeuse dans la région des Trois-Rivières.On trades in the district of Trois-Rivières.It is demande : requested : 1° Que le paragraphe \"6\" de l'article II de 1.That subsection \"o\" of section II of said ladite section \"B\" soit remplacé par le suivant: part \"B\" be replaced by the following: \"&) Juridiction territoriale: La juridiction ter- \"6) Territorial jurisdiction:\u2014 The territorial ritoriale de cette section du décret comprend les jurisdiction of this part of the decree comprises cités des Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, the cities of Trois-Rivières, Cap de la Madeleine Shawinigan Falls, Grand'Mère et la ville de Shawinigan Falls, Grand'Mère and the town St-Tite et le territoire compris dans un rayon of St-Tite and the territory included in a radius de cinq (5) milles de leurs limites, la ville de of five (5) miles from their limits, the town of Louiseville et le territoire compris dans un Louiseville and the territory included in a radius rayon de deux (2) milles de ses limites et la mu- of two (2) miles from its limits and the munic- nicipalité de Ste-Angèle-de-Laval.ipality of Ste Angèle de Laval.Cette juridiction est divisée en quatre (4) This jurisdiction is divided into four (4) zones, de la façon suivante: zones as follows: Zone I: Les cités des Trois-Rivières et Cap- Zone I: The cities of Trois-Rivières and Cap de-la-Madeleine et le territoire compris dans un de la Madeleine and the territory included in a rayon de cinq (5) milles de leurs limites.radius of five (5) miles from their limits.Zone II: Les cités de Shawinigan Falls et Zone II: The cities of Shawinigan Falls de Grand'Mère et le territoire compris dans un and Grand'Mère and the territory included in a rayon de cinq (5) milles de leurs limites.radius of five (5) miles from their limits.Zone III: La ville de Louiseville et le.terri- Zone III: The town of Louiseville and the toire compris dans un rayon de deux (2) milles territory included in a radius of two (2) miles de ses limites.from its limits.Zone IV: La ville de St-Tite, comté de La- Zone IV: The town of St.Tite, Laviolette violette, et un rayon de cinq (5) milles de ses county, and a radius of five (5) miles from its limites.\" limits.\" 2° Que la liste suivante de services et de prix 2.That the following list of services and minima soit ajoutée à l'article IV: minimum prices be added to section IV: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.86, No.24 1987 ZONE IV Coupe de cheveux.$0.50 Ondulation à l'eau.0.60 Fixatif (laque).0.10 Shampooing.0.55 Ondulation permanente à froid.5.00 Ondulation permanente sans machine, sachets chimiques.4.00 Ondulation permanente régulière pour enfants en bas de 12 ans.3.00 Ondulation permanente à froid pour enfants en bas de 12 ans.3.50\" 3° Que les dispositions suivantes concernant la nouvelle zone IV, soient ajoutées au paragraphe \"a\" de l'article V: \"Zone IV: Coiffeurs et Coiffeuses -pour dames: Le lundi: de 7.00 a.m.à 11.00 p.m.; Le mardi: de 7.00 a.m.à 11.00 p.m.; Le mercredi: de 7.00 a.m.à 11.00 p.m.; Le jeudi: de 7.00 a.m.à 11.00 p.m.; Le vendredi: de 7.00 a.m.à 11.00 p.m.; Le samedi: de 7.00 a.m.à 6.00 p.m.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 13 juin 1953.35010-o Avis d'Approbation de Règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la conventiou collective (S.R.Q, 1941, chapitre 163 et amendements), que des règlements spéciaux adoptés par le Comité conjoint des tanneries et corroie-ries de la province de Québec ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 642-E du 29 mai 1953 et ajoutés à la constitution et aux règlements généraux dudit Comité déjà approuvés par l'arrêté en conseil numéro 620-L du 20 mai 1953.En vertu de la Loi, les dispositionssuivantes desdits règlements spéciaux ont été déclarées obligatoires: \"Règlements spéciaux Tenue du registre: Conformément au paragraphe \"g\" de l'article 20 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité paritaire rend obligatoire pour tout employeur professionnel régi par le décret numéro 330 du 19 mars 1953: a) La tenue d'un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l'époque de paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l'application du décret.6) L'usage d'un système d'enregistrement automatique des heures de travail de chaque salarié à son emploi au moyen d'une horloge enregistreuse ou d'un appareil semblable.c) L'enregistrement automatique et la tenue du registre sont exigés pour tout salarié, nommément les contre-maîtres et les techniciens.d) L'usage des enveloppes de paie uniformes fournies et vendues au prix coûtant par le Coin- \"ZONE IV Haircut.$0.50 Water wave.0.60 Lacquer.0.10 Shampoo.0.55 Cold wave.'.5.00 Permanent wave (no machine), chemical pads.4.00 Regular permanent wave for children under 12 years of age.3.00 Cold wave for children under 12 years of age.3.50\" 3.That the following provisions concerning the new zone IV be added to subsection \"a\" of section V: \"Zone IV: Ladies' male and female hairdressrrs: On Monday: from 7.00 a.m.to 11.00 p.m.: On Tuesday: from 7.00 a.m.to 11.00 p.m.: On Wednesday: from 7.00 a.m.to 11.00 p.m.: On Thursday: from 7.00 a.m.to 11.00 p.m.: On Friday: from 7.00 a.m.to 11.00 p.m.: On Saturday: from 7.00 a.m.to 6.00 p.m.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 13, 1953.35010-o Notice of Approval of By-laws Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, heieby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 1G3 and amendments), that special by-laws adopted by the Tanneries and Curriers Joint Committee of the Province of Quebec have been approved bv Order in Council No.642-E of May 29, 1953, and added to the constitution and general by-laws of the said Committee, already approved bv Order in Council No.620-L of May 20, 1953.In pursuance of the Act, the following provisions of the said special by-laws have been rendered obligatory: \"Special By-laics Keeping of a register: In pursuance of subsection \"g\" of section 20 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Parity Committee renders obligatory for every professional cmplover governed by decree No.330 of March 19, 1953: a) The keeping of a register giving the name in full and address of all employees in his employ, their competency or classification, the exact time at which the work was begun, interrupted, resumed and ceased each day, the nature of such work and the wages paid, as well as the mode and period of payment and all other particulars deemed useful to the enforcement of the decree.b) The use of an automatic registration system of the hours of work of all employees in his employ by means of a punch clock or similar device.c) The automatic registration and the keeping of the register apply to all employees, including foremen and technicians.d) The use of standard pay envelopes supplied and sold at cost price by the Committee and 1988 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 jtdn 1953, Tome 85, N° 84 mité et l'inscription des renseignement requis sur les dites enveloppes.\" \"Rapport mensuel: Conformément au paragraphe \"h\" de l'article 20 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendement), le Comité paritaire oblige tout employeur professionnel régi par le décret numéro 330 du 19 mars 1953 à lui transmettre un rapport mensuel par écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable à son emploi, sur lequel doivent être indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulière ou supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.Ledit rapport doit être transmis au Comité paritaire le 10 de chaque mois ou avant et doit couvrir le mois précédent.L'employeur professionnel peut obtenir du Comité paritaire les formules nécessaires pour la préparation dudit rapport.\" Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 13 juin 1953.35010-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les comtés de Joliette, Montcalm, l'Assomption et Berthier, rendue obligatoire par le décret numéro 3751 du 17 décembre 1943, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° Le sous-paragraphe \"6-1\" de l'article IV sera remplacé par le suivant: \"1.Le lundi: entre 7.00 a.m.et midi: Les mardi, mercredi et jeudi: entre 7.00 a.m.et 7.00 p.m.; Les vendredi, samedi et veille de fêtes chômées: entre 7.00 a.m.et 9.00 p.m.Dans les limites de la municipalité de St.Do-nat du comté de Montcalm, du 1er mai au 1er octobre, les heures de travail des barbiers-coiffeurs et des coiffeurs et coiffeuses peuvent être prolongées, les mardi et mercredi, jusqu'à 9.00 p.m.Cependant, dans la cité de Joliette, la ville de l'Assomption et la municipalité de Crabtree, les heures de travail dans les salons de barbier devront se terminer à 6.30 p.m.les mardi, mercredi et jeudi, et à 6.00 p.m.les samedi et veilles de fêtes chômées.\" 2° L'alinéa suivant sera ajouté à l'article VI: \"Sur demande du Comité paritaire, on devra afficher et maintenir affichée dans tous les salons de barbier, de coiffeur ou de coiffeuse, une carte reproduisant les prix minima ci-haut mentionnés à être fournie par ledit Comité.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 13 juin 1953.35010-o the inscription of required particulars on said envelopes.\" \"Monthly report: In pursuance of subsection \"/*\" of section 20 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Parity Committee requires every professional employer governed by decree No.330 of March 19, 1953, to submit to it a monthly report in writing, signed by himself or by an authorized person in his employ, on which the following particulars shall be given: the name in full and address of all employees in his employ, their competency or classification, the number of regular and overtime hours worked each week, the nature of such work and the wages paid.This report shall be forwarded to the Parity Committee on or before the 10th day of each month and shall apply to the preceding month.Professional employers may obtain from the Parity Committee the forms on which the reports are to be made.\" GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 13, 1953.35010-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the counties of Joliette, Montcalm, L'Assomption and Berthier, rendered obligatory by the decree No.3751 of December 17, 1943, have submitted to him a petition to amend the said decree, as amended, as follows: 1° Paragraph \"6-1\" of section IV will be replaced by the following: \"1.Monday: between 7.00 a.m.and 12.00 noon) ; Tuesday, Wednesday and Thursday: between 7.00 a.m.and 7.00 p.m.; ' Friday, Saturday and holiday eves: between 7.00 a.m.and 9.00 p.m.Within the limits of the municipality of St.Donat, in the county of Montcalm, from May 1st to October 1st, the hours of work of barbers and male and female hairdressers may be extended, on Tuesday and Wednesday, until 9.00 p.m.However, in the city of Joliette, in the town of L'Assomption and in the municipality of Crab-tree, the hours of work in barber shops shall end at 6.30 p.m.on Tuesday, Wednesday and Thursday, and at 6.00 p.m.on Saturday and holiday eves.\" 1.The following paragraph will be added to section VI: \"Upon request from the Parity Committee, a card with the minimum prices above mentioned shall be posted and kept posted in every barber or hairdressing parlor; this card shall be supplied by the said Committee.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 13, 1953.35010-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1963, Vol.86, No.24 1989 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de l'isolement en amiante, rendue obligatoire par 'n Section \"B\" du décret numéro 411 du 17 avril 1952, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ladite Section \"B\" (article XXII-B) de la façon suivante: 1° Les mots \"à l'air\" apparaissant au paragraphe \"a\" dudit article XXII-B seront radiés.2° Les mots \"et après 4.30 p.m.le samedi\" seront ajoutés au paragraphe \"c\" du même article.3° Le nombre \"2000\" apparaissant au paragraphe \"/\" dudit article sera remplacé par \"2080\".4° Le paragraphe \"g\" dudit article sera rem- placé par le suivant: g) Taux minima de salaires: l'heure 1° Apprentis: 1ère année.S0.95 2ème année.1.15 3ème année.1.30 Mécanicien junior.1.50 Mécanicien en isolement d'amiante.1.90 2° Contremaître: S'il dirige une équipe d'au moins cinq (5) hommes.2.00 S'il dirige une équipe d'au moins dix (10) hommes.2.05 S'il dirige une équipe d'au moins quinze (15) hommes.2.10 S'il dirige une équipe de vingt (20) hommes ou plus.2.15\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, 'lhonorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 13 juin 1953.35010-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi, rendue obligatoire par le décret numéro 488 du 2 mai 1951, lui ont présenté une requçte à l'effet de modifier ledit décret de la façon suivante: 1° L'article II sera remplacé par le suivant: \"JX Juridiction territoriale: Le décret s'applique aux cités de Chicoutimi et d'Arvida, aux villes de Jonquière, Kénogami, Bagotville, Port-Alfred, Chicoutimi-Nord, Rivière-du-Moulin, St-Bruno, St-Joseph d'Alma, Naudville et St-Cœur de Marie, à la municipalité de St-Alexis-de-la-Grande-Baie et à la paroisse de Larouche et un rayon de cinq (5) milles de leurs limites.\" 2° Le paragraphe \"a\" de l'article IV sera remplacé par le suivant: NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby givesn oticc, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the asbestos insulation industry, rendered obligatory by Part \"B\" of the decree number 411 of April 17, 1952, relating to the construction industry and trades in the district of Montreal, have submitted to him a petition to amend the said Part \"B\" (Section XXII-B) as follows: 1.The word \"air\" mentioned in subsection \"a\" of the said section XXII-B will be deleted.2.The words \"and after 4.30 p.m.Saturday\" will be added to subsection \"c\" of the same section.3.The numeral \"2000\" mentioned in subsection \"/\" of said section will be replaced by \"2080\".4.Subsection \"g\" of said section will be replaced by the following: \"g) Minimum wages rates: per hour 1.Apprentices: 1st year.$0.95 2nd year.1.15 3rd year.1.30 Junior mechanic.1.50 Asbestos insulation mechanic .1.90 2.Foreman: in charge of at least 5 men .2.00 in charge of at least 10 men .2.05 in charge of at least 15 men____ 2.10 in charge of 20 men or more .2.15\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department or Labour, Quebec, June 13,1953.35010-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to service and gasoline stations in the region of Chicoutimi, rendered obligatory by the decree No.488 of May 2, 1951, have submitted to him a petition to amend the said oecree as follows: 1.Section II will be replaced by the following: \"II.Territorial jurisdiction: The eecree applies to the cities of Chicoutimi and Arvida, to the towns of Jonquière, Kénogami, Bagotville, Port-Alfred, Chicoutimi-Nord, Rivière-du-Moulin, St.Bruno, St-Joseph d'Alma, Naudville and St.Coeur de Marie, to the municipality of St.Alexis-de-la-Grande-Baie and to the parish of Larouche and a radius of five (5) miles from their limits.\" 2.Subsection \"a\" of section IV will be replaced by the following: 1990 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 juin 1958, Tome 85, N° 24 \"a) La durée régulière du travail est de soixante-trois (63) heures par semaine réparties corn-suit: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 7.00 a.m.à 8.00 p.m.: Les vendredi, samedi et veille de fêtes chômées: de 7.00 a.m.à 9.00 p.m.\" 3° Le paragraphe \"g\" suivant sera ajouté à l'article IV: >lg) Les pompes à gazoline ne doivent pas être illuminées en dehors des heures ci-haut mentionnées.\" 4° Le paragraphe \"a\" de l'article VI sera remplacé par le suivant: \"a) Les taux minima de salaires sont les suivants: Salaires hebdomadaires 1er semestre (commençant).$22.75 Après six (6) mois de service.27.50 Après dix-huit (18) mois de service .33.00 Après trente (30) mois de service.33.50 Contremaître.44.00\" 5° Le paragraphe V suivant sera ajouté à l'article VIII: \"e) Les droits déjà acquis par les salariés en regard des vacances payées ne doivent aucunement être affectés par un changement de propriétaire du poste de service.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 13 juin 1953.35010-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier-coiffeur dans la cité de St-.Iean et la ville d'Iberville et un rayon de trois (3) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret numéro 3011 du 6 novembre 1941, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° L'article III sera remplacé par le suivant: \"III.Durée du travail: Les heures de travail sont les suivantes pour toutes les catégories de salariés : a) Dans la cité de St-Jean et la ville d'Iberville et le territoire compris dans un rayon de trois (3) milles de leurs limites: Le lundi: de 9.00 a.m.à 6.00 p.m.Les mardi, mercredi et jeudi: de 9.00 a.m.à 7.00 p.m.Le vendredi: de 9.00 a.m.à 9.00 p.m.Le samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Si le lundi, le mardi ou le mercredi précèdent une fête chômée, les heures de travail seront de 9.00 a.m.à 7.00 p.m.Si le jeudi ou le vendredi précède une fête chômée, les heures de travail seront de 9.00 a.m.à 9.00 p.m.Si la veille de Noël et du Premier de l'An tombent un samedi, les heures de travail seront de 9.00 a.m.à 9.00 p.m.6) La ville de Farnham et un rayon de trois (3) milles de ses limites: \"a) The standard duration of work consists of sixty-three (63) hours per week distributed as follows: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday: 7.00 a.m.to 8.00 p.m.; Friday, Saturday and holiday eves: 7.00 a.m.to 9.00 p.m.3.The following subsection \"g\" will be added to section IV: \"g) Gasoline pumps shall not be lighted beyond the hours above mentioned.\" 4.Subsection \"a\" of section VI will be replaced by the following: \"a) The minimum wage rates shall be as follows: Weekly wages 1st six months (beginner).$22.75 After six (6) months of service.27.50 After eighteen (18) months of service .33.00 After thirty (30) months of service____ 33.50 Foreman.44.00'* 5.The following subsection \"e\" will be added to section VIII: \"e) Vested rights of employees as regards vacation with pay shall not be affected by a change of station owner.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 13, 1953.35010-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 et amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdressing trades in the city of St.John and the town of Iberville and a radius of three (3) miles from their limits, rendered obligatory by the decree No.3011 of November 6, 1941, have submitted to him a petition to amend the said decree, as amended, as follows: 1.Section III will be replaced by the following: \"III.Duration of work: The hours of work shall be as follows for all categories of employees: o) In the City of St.John and the town of Iberville, and the territory comprised in a radius of three (3) miles from their limits: Monday: 9.00 a.m.to 6.00 p.m.Tuesday, Wednesday and Thursday: 9.00 a.m.to 7.00 p.m.Friday: 9.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.When Monday, Tuesday or Wednesday precede a holiday, the hours of work shall be from 9.00 a.m.to 7.00 p.m.When Thursday or Friday precede a holiday, the hours of work shall be from 9.00 a.m.to 9.00 p.m.When Christmas and New Year's Eve fall on Saturday, the hours of work shall be from 9.00 a.m.to 9.00 p.m.b) The town of Farnham and a radius of three (3) miles from its limits: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, June 13th, 1953, Vol.86, No.24 1991 Le lundi: aucun travail n'est exécuté, excepté pendant les semaines où il y a une fête chômée le mardi: Les mardi, mercredi, jeudi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Le samedi: de 8.00 a.m.à 8.00 p.m.c) La ville de Cowansville et le village de Sweetsburg: \u2022 Le lundi: de 8.00 a.m.à midi* excepté pendant les semaines où il y a une fête chômée le mardi.Les mardi et jeudi: de 8.00 a.m.à 7.00 p.m.Le mercredi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Le samedi et la veille de fête chômée: de 8.00 a.m.à 8.00 p.m.Le tout formant un total hebdomadaire de soixante-et-une (61) heures.d) La ville de Bedford et un rayon de trois (3) milles de ses limites: Les lundi et mardi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le mercredi: de 8.00 a.m.à 12.30 p.m.Le jeudi: de 8.00 a.m.à 8.30 p.m.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Le samedi: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.Le tout formant un total hebdomadaire de soixante-quatre (64) heures.e) Les fêtes chômées, c'est-à-dire les jours où il n'y a pas de travail, sont les suivants: Les dimanches, le Premier de l'An, l'Epiphanie, l'Ascension, la Toussaint, l'Immaculée Conception, la Noël, la St-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération, le Jour d'Action de Grâces et la fôte du Travail./) L'heure ci-dessus mentionnée pour la durée du travail est l'heure légale; toutefois, si l'autorité civile décrète l'avance de l'heure pour une période de l'année, l'heure ainsi avancée devient l'heure légale pour l'application du présent décret.g) Nonobstant la répartition des heures mentionnées aux paragraphes \"a\" et \"c\" du présent article, il est permis, sans violation du décret, de servir les clients qui sont entrés dans un salon avant l'expiration des heures de travail, à condition que ceux-ci ne s'absentent pas du salon.h) Tout employé-barbier a le droit de prendre une heure pour le repas du midi chaque jour et une demi-heure pour le repas du soir, excepté le lundi.Réserve: Nonobstant les dispositions du présent décret, la durée des heures de travail dans les salons de barbiers, de coiffure et de beauté ne doit en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de la Loi des Établissements Industriels et Commerciaux (Statuts Refondus de Québec, 1925, chapitre 182 et amendements), aux décrets faits sous son autorité et aux règlements établis par les municipalités compétentes.\" 2° L'article IV sera remplacé par le suivant.\"IV.Taux minima de salaires: Les taux minima de salaire sont les suivants: a) Les employés barbiers-coiffeurs doivent recevoir $30.00 par semaine plus 50% des recettes de leur travail excédant $40.00 au cours de la semaine.b) Les employés surnuméraires doivent recevoir $0.55 l'heure plus 50% des recettes de leur travail excédant $7.00 au cours de la journée.c) Aucun employeur n'a le droit de réduire le salaire d'un employé-barbier recevant plus que les taux minima ci-haut mentionnés lors de la mise en vigueur du présent décret.\" 3° Le paragraphe \"a\" de l'article V sera remplacé par le suivant: Monday: No work is performed except when a holiday falls on Tuesday.Tuesday, Wednesday, Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.c) The town of Cowansville and the village of Sweetsburg: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon), except when a holiday falls on Tuesday.Tuesday and Thursday: 8.00 a.m.to 7.00 p.m.Wednesday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.Making a wcelkly total of sixty-one (61) hours.d) The town of Bedford and a radius of three (3) miles from its limits: Monday and Tuesday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Wednesday 8.00 a.m.to 12.30 p.m.Thursday: 8.00 a.m.to 8.30 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.Making a weekly total of sixty-four (64) hours.e) Holidays, that is, days on which no work is to be performed, shall be the following: Sundays, New Year's Day, Epiphany, Ascension Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day, Christmas Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day, Thanksgiving Day and Labour Day./) The time hereinabove mentioned for the duration of labour shall be the legal time: however, should the Civil Authority enact the Eastern Daylight Saving Time for a period of the year, it shall become the legal time for the enforcement of the present decree.g) Notwithstanding the distribution of the hours mentioned in sub-sections \"a\" and \"c\" of the present section it shall be allowed, without violating the decree, to attend on clients who are in the parlor before the expiration of working hours, provided said clients do not leave the parlor.h) Any barber-employee shall have the right to take one hour off for the noon meal, every day, and one half-hour for the evening meal, except on Monday.Proviso: Notwithstanding the provisions of the present decree, the duration of the working hours in barber shops and hairdressing and beauty parlors must not constitute a derogation of the provisions of the Industrial and Commercial Establishments' Act (Quebec Revised Statutes, 1925, chapter 182 and amendments), of decrees enacted under its authority and of regulations established by competent municipalities.2.Section IV will be replaced by the following: \"IV.Minimum rates of wages: The minimum rates of wages shall be as follows: a) The barber-hairdresser employees shall receive $30.00 per week plus 50% of the receipts of their work exceeding $40.00 in the course of the week.6) Occasional employees shall receive $0.55 per hour plus 50% of the receipts of their work exceeding $7.00 during the day.c) No employer shall have the right to reduce the wages of an employee receiving more than the minimum rates hereinabove mentioned at the time of the coming into force of this decree.\" 3.Subsection \"a\" of section V will be rplaced by the following: 1992 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1958, Tome 85, N° 24 \"a) Prix minima des services: Les employeurs professionnels, les salariés et les artisans doivent charger au public les prix minima suivants pour les services ci-dessous mentionnés: Barbe ./.$0.40 Coupe de cheveux pour adultes des deux sexes.0.75 Brosse pour adultes, hommes.0.85 Coupe de cheveux pour enfants des deux sexes, 14 ans et moins: Mardi, mercredi, jeudi.0.40 Vendredi, samedi et veille de fête.0.50 Brosse pour enfants, 14 ans et moins: Vendredi, samedi et veille de fête.0.50 Mardi, mercredi et jeudi.0.50 Flambage des cheveux.0.25 Shampooing à l'huile spécial.0.75 Shampooing ordinaire .0.50 Massage au vibrateur citron et rose.0.50 Massage lotion.0.30 Lotion.0.35 Lotion ordinaire.0.30 Tonique.0.35 Massage Boncilla.0.75 Massage noir à la glaise.1.00 Rasage du cou.0.15 Aiguisage de ciseaux.0.25 Aiguisage de rasoir.0.50 Coupe de cheveux à domicile.1.00 Rasage à domicile.1.00 Les prix minima ci-haut mentionnés s'appliquent également aux institutions d'enseignement et de charité.Cependant, le travail qui est effectué ne doit pas être considéré comme des services rendus à domicile.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 13 juin 1953.35010-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de quincaillerie, ferronnerie et peinture dans les cités de Québec et Lévis et la ville de Lauzon, rendu obligatoire par le décret numéro 1090 du 7 mars 1940, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° Le deuxième alinéa du paragraphe \"j\" de l'article II sera remplacé par le suivant: \"Toutefois, après une année de service comme messager, le salarié doit être classifié dans une des catégories de commis mentionnées au décret et l'année de travail comme messager ne doit pas être compté comme année d'expérience comme commis dans la catégorie dans laquelle le salarié est classifié.\" 2° Le paragraphe \"k\" de l'article II sera remplacé par le suivant : \"k) Le terme \"employé junior\" désigne tout salarié exécutant le travail ordinairement reconnu sous le nom d'ouvrage général, garçon de magasin, garçon d'ascenseur; toutefois, après \"a) Minimum prices of services: Professional employers, employees and artisans shall charge to the public the following minimum prices for the services hereunder mentioned: Shave.$0.40 Haircut, male and female adults.0.75 Brushcut, male adults.0.85 Haircut, male and female children up to and including 14 years of age: Tuesday, Wednesday and Thursday .0.40 Friday, Saturday and holiday eves.0.50 Brushcut, children up to and including 14 years of age: Tuesday, Wednesday and Thursday.0.50 Friday, Saturday and holiday eves.0.50 Singeing of the hair.,.0.25 Special oil shampoo.0.75' Ordinary shampoo.0.50 Vibrator massage, lemon and \"rose\".0.50 Massage-lotion.0.30 Lotion.«.0.35 Ordinary lotion.0.30 Tonic.j____ 0.35 Boncilla massage.*.0.75 Mudpack.1.00 Neckshave.0.15 Scissors setting.0.25 Razor setting.0.50 Haircut at home.1.00 Shave at home.1.00 The above minimum prices also apply to educational and charitable institutions.However, all services rendered in such institutions shall not be considered as services rendered at home.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.' GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 13, 1953.3l0S0- NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163, as amended), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the hardware and paint trade in the cities of Quebec and Levis and the town of Lauzon, rendered obligatory by the decree number 1090 of March 7,1940, have submitted to him a request to amend the said decree, as amended, as follows: 1.The second paragraph of subsection \"j\" of section II will be replaced by the following: However, after one year of service as messenger, the employee shall be classified in one of the clerk categories mentioned in the decree and that year of work as messenger shall not be considered as a year of experience as clerk in the category in which the employee is classified.2.Subsection \"A\" of section II will be replaced by the following: k) The words \"junior employee\" mean any employee doing the work ordinarily called \"general work,\" or that of store or elevator boy; however, after one year of work in this classifica- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 13th, 1953, Vol.85, No.24 1993 cette année «le travail dans cette classification le salarié doit être classifié dans une\" «les catégories de commis décrites au «lécret et l'année de travail comme employé junior ne doit pas être comptée comme année d'expérience dans la catégorie de commis dans laquelle le salarié est classifiç.\" 3° Le dernier alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe \"b\" de l'article III sera remplacé par le suivant: \"En dehors des heures mentionnées ci-haut, un salarié-ne peut travailler et un employeur ou un employeur professionnel ne peut faire travailler un salarié à la vente dans un établissement régi par le présent décret.\" 4° A l'article IV, les taux de salaires minima mentionnés pour les classifications d'emploi ci-après énumérécs, seront remplacé par les suivants: par semaine \"o)l.Gérant.$63.00 2.Chef-comptable.56.50 2.1er commis à la vente.56.50 4.1er commis réception et expédi- tion.53.00 5.1er commis aux commandes.53.00 b) Livreur.45.50 c) Aitle-livreur\u2014moins21 ans.29.00 Aide-livreur\u201421 ans et plus.33.50 d) Messager.15.00 /) Personnel masculin de bu reau: 1ère année.21.50 2ème année.25.50 3ème année.28.50 4ème année.33.00 5ème année.38.50 6ème année.42.50 7ème année.46.00 8ème année.49.50 9ème année.53.00 g) Commis à la vente: 1ère année.20.00 2ème année.23.50 3ème année.28.50 4ème année.32.00 5ème année.37.00 6ème année.41.50 7ème année.43.50 8ème année.48.50 9ème année.53.00 h) Commis à réception et expédition: 1ère année.21.50 2ème année.25.50 3ème année.28.50 4ème année.33.00 5ème année.36.00 6ème année.' 39.00 7ème année.40.00 8ème année.'.43.00 9ème année.45.50 i) Commis aux commandes: 1ère année.21.50 2ème année.25.50 \u2022 3ème année.28.50 4ème année.33.00 5ème année.36.00 6ème année.39.00 7ème année.41.50 8ème année.45.50 9ème année.48.50 l'heure le) Commis supplémentaire.$0.90 1.) Commis su rnuméraire.0.60 m) Personnel féminin de bureau: par semaine 1ère année.$20.00 2ème année.24.50 3ème année.29.50 tion, the employee shall be classified i none of the clerk categories describe*! in the decree and that year of work as junior employee shall not be considered as a year of experience in the clerk category in which the employee is classified.3.The last sub-paragraph of paragraph 3 of subsection \"b\" of section III will be replaced by the following : Outside the hours mentioned above, no employee shall work and no employer or professional employer shall cause sales work to be done by an employee in an establishment governed by the present decree.4.The minimum wage rates for the following classifications of employment, as mentioned in section IV, will replaced by the following: per week \"a) 1.Manager.$63.00 2.Chief-accountant.56.50 3.Head sales-clerk.56.50 4.Head receiving and shipping clerk.53.00 5.Hea«l order clerk.53.00 b) Delivery-man.45.50 c) Delivery-man's helper: under 21 years of age.29.00 21 years of age and over.33.50 d) Messenger.15.00 /) Male office clerk: 1st year.21.50 2nd year.25.50 3rd year.28.50 4th year.33.00 5th year.38.50 6th year.42.50 7th year.46.00 8th year.49.50 9th year.53.00 g) Sales clerk: 1st year.20.00 2nd year.23.50 3rd year.28.50 4th year.32.00 5th year.37.00 6th year.41.50 7th year.43.50 8th year.48.50 9thyear.53.00 h) Receiving and shipping clerk: 1st year.21,50 2nd year.25.50 3rd year.28.50 4th year.33.00 5th year.36.00 6th year.39.00 7th year.40.00 8th year.43.00 9th year.45.50 i) Orders clerk: 1st year.21.50 2nd year.25.50 3rd year.28.50 4th year.33.00 5th year.36.00 6th year.39.00 7th year.41.50 8th year.'.45.50 9th year.48.50 per hour k) Extra clerk.$0.90 /) Supernumery clerk.0.60 m) Female office clerk: per week lstvear.20.00 2nd year.24.50 3rd year.29.50 1994 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 juin 1953, Tome 85, N* 24 4ème année.33.00 mm) Autre personnel féminin:.1ère année.19.00 2ème année.22.50 3ème année.27.00 4ème année.29.50 n) 1.Ouvriers
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.