Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 juin 1953, samedi 27 (no 26)
[" Tome 85, N° 26 2085 Vol.85, No.26 I ! Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 27 juin 1953 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1953.Québec, le 8 juin 1953.L'Imprimeur de la Reine.35004-24-12-o RÊDEMPTI PARADIS.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 27th, 1953 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1953.Quebec, this 8th, of June 1953.REDEMPTI PARADIS, 35004-24-12-o .Queen's Printer.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2086 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1958, Tome 85, N° 26 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc: Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lign.es par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre: le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u2014 1-52 the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order ot the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning: but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to -the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc : First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines, to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number: the second to that of the edition of the Gaiette for the first insertion: the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.REDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u2014 1-52 Lettres patentes Acier d'Armature Ltée Armature Steel Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies.de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt mai 1953, constituant en corporation: Yves Pratte, avocat, de Sillery, Paul Normandin, étudiant, et Paillette Belleau, secrétaire, céliba- Letters Patent Acier d'Armature Ltée Armature Steel Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of May, 1953.incorporating: Yves Pratte, advocate, of Sillery, Paul Normandin, student, and Pau-lette Belleau, secretary, spinster, both of Quebec, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1963, Vol.85, No.26 2087 taire, tous deux de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire commerce de métaux de toutes sortes à l'état brut, semi-fini et fini, et sous-produits du métal et de tous objets dans la composition desquels entrent du métal, ses produits et ses sous-produits, sous le nom de \"Acier d'Armature Ltée\" \u2014 \"Armature Steet Ltd.\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.Allied Film Laboratories Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.Lalti-chelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-deux mai 1963, constituant en corporation: Paul S.Mattey, photographe, Stepan Urbanek, technicien, Alexander Biega, avocat, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de pellicules cinématographiques; exploiter un poste d'émission et de réception radiophoniques et télévisées; organiser, projeter et diriger des productions cinématographiques, sous le nom de \"Allied Film Laboratories Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal) Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Armand Rémillard Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patehtse, en date du quinze mai 1953, constituant en corporation: Stanislas Déry, avocat, Armand Rémillard, marchand, et Roméo Bordeleau, comptable, tous de la cité de Saint-Jean, district judiciaire d'Iber-ville, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Armand Rémillard Limitée\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 500 actions sans valeur au pair ou nominale et en 77Ô actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire dTberville.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1953.* L'Assistant-procureur général, 35079-o ' L.DÉSILETS.Bellevue Housing Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi de3 compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in metals of all kinds in the raw state, partly finished and finished, and by-products of metal and of any object into which metal enters, its products and by-products, under the name of \"Acier d'Armature Ltée\" \u2014 \"Armature Steel Ltd.\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Allied Film Laboratories Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of May, 1953, incorporating: Paul S.Mattey, photographer, Stepan Urbanek, technician, Alexander Biega, advocate, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal with kinematogra-phic films; to operate a broadcasting and receiving station of rado and television; to organize, plan and direct kinematographic productions, under the name of \"Allied Film Laboratories Limited\", with a capital stock of $50,000.divided into 500 shares of $100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Armand Rémillard Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of May, 1953, incorporating: Stanislas Déry, advocate, Armand Rémillard, merchant, and Roméo Bordeleau, accountant, all of the city of Saint-John, judicial district of Iberville, for the following purposes: To deal in furniture of all kinds and descriptions, under the name of \"Armand Rémillard Limitée\".The capital stock of the company is divided into 500 shares of no par or nominal value and into 770 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-John, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of may, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Bellevue Housing Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, inc onformity with section 2, chapter 2088 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 276.S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du douze mai 1953, constituant en corporation: Harry Blank, avocat.Blanka Gyulai, teneuse de livres, et June Kirlin, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir un certain terrain dans le but d'ériger ou d'y faire ériger des construct ions d'un genre résidentiel ou commercial pour fin de revente, sous le nom de \"Bellevuc Housing Con).\", avec un capital de 840.000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de §100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1953.L'Assist an t -procu reu r général, 35079 L.DÉSILETS.276, R.S.Q.1941, bearing date the twelfth day of May, 1953, incorporating: Harry Blank, advocate, Blanka Gyulai, bookkeeper, and June Kirlin, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes; To acquire a certain land for the purpose of erccting or having erected thereon, buildings of a residential and commercial nature for resale, under the name of \"Bellevue Housing Corp.'\\ with a capital stock of S40.000.divided into 300 preferred shares having a par value of $100.each, and 100 common shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Bolam Lumber Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté ppr M.C.La-Richelièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix-neuf mai 1953, constituant en corporation: Charles R.Bolam, propriétaire de scierie et marchand de bois.Dame Fernande Chevricr Bolam, ménagère et conseillère en commerce, épousé commune en biens de Charles R.Bolam et dûment autorisée par lui, tous deux du village de Campbell's Bay, district judiciaire de Pontiac, et Alexis H.Shaw, agent d'assurances, de la cité d'Ottawa, comté de Carleton, province d'Ontario, pour les objets suivants: ' Faire le commerce de billots, bois de pulpe, bois de construction, matériaux de construction, ainsi que tous autres sous-produits d'iceux, comme manufacturiers, grossistes et détaillants, sous le nom de \"Bolam Lumber Company Ltd.\" Le capital-actions de la compagnie est divisé en 4,000 actions ordinairsc sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera au village de Campbell's Bay, district judiciaire de Pontiac.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Cartier Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patetnes en date du vingt-trois mai 1953, constituant en corporation: David Goodman, avocat, de Hampstead, Jack Lightstone> avocat, Roslyn Soloway, secré-tarie, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'ustensiles de cuisine, articles de ménage et d'objets ordinairement fournis ou négociés par les bijoutiers, sous le nom de \"Cartier Ltée\", avec un capital de $75,000 divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Bolam Lumber Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richclière, in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q.1941, bearing date the nineteenth day of May, 1953, incorporating: Charles-R.Bolam, saw-mill proprietor and lumberman, Dame Fernande Chevrier Bolam, housekeeper and business adviser, wife common as to property of Charles-R.Bolam and duly authorized by him, both of the Village of Campbell's Bay, judicial district of Pontiac, and Alexis H.Shaw, insurance agent, of the city of Ottawa, County of Carleton, province of Ontario, for the following purposes: To deal in logs, pulpwood, lumber, buildings materials as well as all other by-products of same, as manufacturer, wholesaler and retailer, under the name of \"Bolam Lumber company Ltd.\", The capital stock of the company is divided into 4,000 common shares having no nominal or par value; The head office of the Company will be at the Village of Campbell's Bay, in the judicial district of Pontiac.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Cartier Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of May, 1953, incorporating: David Goodman, advocate, of Hampstead, Jack Lightstone, advocate, Roslyn Soloway, secretary, fille majeure, both of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in kitchen ware, household wares, articles commonly supplied or dealt in by jewellers, under the name of \"Cartier Ltée\", with a capital stock of $75,000.divided into 2,500 common shares of the par value of $10.each, and 5,000 preferred shares of the par value of $10.each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2089 Le siège social de la compagnie sera à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.The head office of the Company will be at Three Rivers, Judicial district of Three Rivers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Ça Va! Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de mai 1953, constituant en corporation: Conrad Shatner, avocat, Morris Shuter, teneur de livres, Gloria Williams, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Administrer et exploiter des restaurants, sous le nom de \"Ça Va! Ltée.\" avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-huitième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Ça Va! Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelîère, in conformity with section 2, chapter 270, R.S.Q.1911, bearing date the twenty-eighth day of May, 1953, incorporating: Conrad Shatner, advocate, Morris Shuter, bookkeeper, Gloria Williams, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manage and conduct restaurants, under the name of \"Ça Va! Ltée\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, .35079-o Deputy Attorney General.Citadel Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt et un mai 1953, constituant en corporation: Alan Macnaughton, c.r., avocat, Pauline Bélanger, Gisèle Dionne, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à négocier des immeubles, sous le nom de \"Citadel Realties Limited\", avec un capital de $5,000 divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Citadel Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued.by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelicre, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of May, 1953, incorporating: Alan Macnaughton, Q.C., lawyer, Pauline Bélanger, Gisèle Dionne, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealing in real estate ,under the name of \"Citadel Realties Limited\", with a capital stock of $5,000.divided into 1,000 shares of the par value of $5.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Colibri Company of Canada Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date 1,4 du vingt-huitième jour de mai 1953, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, avocat, de la cité de Westmount, Jack Lightstone, avocat, Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de briquets, accessoires et articles de fumeurs, objets divers, cadeaux, nouveautés et articles de maison, sous le nom de \"Colibri Company of Canada Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de*j$100 chacune et500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Colibri Company of Canada Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth day of May, 1953, incorporating: Philip Fischel Vineberg, advocate, of the city of Westmount, Jack Lightstone, advocate, Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of the city of Montieal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in lighters, smokers accessories and supplies, and sundries, giftware, novelties and household articles, under the name of \"Colibri Company of Canada Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 350 preferred shares of the par value of $100.each, and 500 common shares of the par value of $10.each. 2090 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1958, Tome 85, N° 26 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-huitième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Confection pour Hommes Gossclin Men's Shop Chicoutimi Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1953, constituant en corporation: Georges Beauchamp, commerçant, de Kénogami, Rober Gosselin, commerçant, Louis-P.Gauthier, courtier d'assurances, tous deux de Jonquière, tous du district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchandises sèches, sons le nom de \"Confection pour Hommes Gosselin Men's Shop Chicoutimi Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.Delorimier Bar-B-Q.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1953, constituant en corporation: Raymond Lebœuf, avocat, Raoul Laforte, comptable, Gisèle Behocaray, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de restaurateur, sous le nom de \"Delorimier Bar-B-Q- Inc\", avec un capital de $25,000 divisé en 25,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.D.Vandal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRi-chelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1953, constituant en corporation: Henri Morin, notaire, Marcel Rivard, comptable, Marcel Morin, notaire, tous des cité et district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce des eaux gazeuses et eaux minérales, sous le nom de \"D.Vandal Inc.\", avec un capital de $184,990 divisé en 999 actions communes d'une valeur au pair de $10.chacune et en 1,750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.The head office of the Company will be at lMontreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Confection pour Hommes Gosselin Men's Shop Chicoutimi Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant Governor of the province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.W., 1941, bearing date the twenty-first day of May, 1953, incorporating: Georges Beau-champ, dealer, of Kenogami, Roger Gosselin, dealer, Louis P.Gauthier, insurance broker, both of Jonquière, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in and carry on the business of dry-goods, under the name of \"Confection pour Hommes Gosselin Men's.Shop Chicoutimi Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Delorimier Bar-B-Q.Inc.« Notice is given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of May 1953, incorporating: Raymond Leboeuf, advocate, Raoul Laforte, accountant, Gisèle Behocaray, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant-keeper, under the name of \"Delorimier Bar-B-Q.Inc.\", with a capital stock of $25,000 divided into 25*000 shares of $1 each.The head office of the Company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of May 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.D.Vandal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tjhe Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, bearing date the*»twenty-second day of May, 1953 .incorporating: Henri Morin, notary, Marcel Rivard, accountant, Marcel Morin, notary, all of the city and judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To manufacture and deal in gaseous and mineral waters, under the name of \"D.Vandal Inc.\", with a capital stock of $184,990, divided into 999 common shares of a par value of $10 each and into 1,750 preferred shares of a par value of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2091 Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.Eastree Lumber & Builders Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu.de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur delà province de Québec, représenté par M.C.La-Ricehlière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941.des lettres patentes en date du vingt-sixième jour de mai 1953, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, Harry Lyon Aronovitch, avocat, Freda Pomcrance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers, marchands de toutes sortes d'accessoires pour constructeurs, bois de construction et bois de toutes sortes, sous le nom de \"Eastree Lumber & Builders Supplies Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sièges ocial de la compagnie sera à l'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-sixième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.East Trinity Mining Corporation (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.La-ichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt mai 1953, constituant en corporation: Georges H.Dumont, ingénieur minier, Gaston Duval, comptable, Lorenzo Gauthier, photographe, Marie Duval, sténographe, fille majeure, Armand Gilbert, notaire, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: » Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais, et les négocier, sous le nom de \"East Trinity Mining Corporation\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capitaine $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Fondation Les Amis de l'Art Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par.M.C.LaRichelière, conformément à l'article The head office of the Company will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney Genera.l Eastree Lumber & Builders Supplies Inc- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La' Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of May, 1953, incorporating: Samuel Chait, advocate, Harry Lyon Aronovitch, avdocate, Freda Pomerance, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers, dealers in all kinds of builders' supplies, in lumber and wood of all kinds, under the name of \"Eastree Lumber & Builders Supplies Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 100 common shares of thepar value of $100.each and 300 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at L'Abord-à-PIouffe, in the judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-O Deputy Attorney General.East Trinity Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of May, 1953, incorporating: Georges-H.Dumont, mining engineer, Gaston Duval, accountant, Lorenzo Gauthier, photographer, Marie Duval, stenographer, of full age, Armand Gilbert, notary, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, and deal with the same, under the name of \"East Trinity Mining Corporation\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4,000,000.divided into 4,000,000 shares of $1.each.The shareholders, will incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will be at Val d'Or, in the judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-O Deputy Attorney General.Fondation Les Amis de l'Art Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with 2092 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, Section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing en date du vingt-six mai 1953, constituant en date the twenty-sixth day of May, 1953, to corporation sans capital-actions: dame Aline incorporate as a corporation without share- Perrier, épouse contractucllemcnt séparée de capital: Dame Aline Pcrrier, wife, separate as to biens de l'honorable juge Hector Perrier, Grace property by marriage contract, of the Honourable Elliott Trudeau, veuve de J.C.E.Trudeau, Judge Hector Perrier, Grace Elliot Trudeau, ménagères, de la cité d'Outrcmont, Violette G.widow of .J.C.E.Trudeau, housewife of the city Monast, épouse contractucllemcnt séparée de of Outremont, Violette G.Monast, wife, separate biens de Charles Monast, ménagère, et Tréfilé as to property by marriage contract, of Charles Boulanger, directeur des études à la Commission Monast, housewife, and Trefflé Boulanger, head- des Écoles Catholiques de Montréal, tous deux master of studies at the Catholic School Coni- de la cité de Montréal, tous du district judiciaire mission of Montreal, both of the city of Montreal, de Montréal, pour les objets suivants: all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: Recevoir et maintenir un ou des fonds pour To raise and maintain a fund or funds to perpétuer par des bourses d'études à fins cultu- perpetuate the name of the \"Fondation Les relies et artistiques le nom de la \"Fondation Amis de L'Art\", by means of scholarships for Les Amis de L'Art\", sous le nom de \"Fondation cultural and artistic purposes, under the name Les Amis de L'Art\".of \"Fondation Les Amis de L'Art\".Le montant auquel sont limités les biens im- The amount to which the value of immoveable mobiliers que la corporation peut posséder, est propertv, which the corporation may hold, is de $100,000.limited,' to $100,000.Le siège social de la corporation sera à Mont- The head office of the corporation shall be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General, six mai 1953.the twenty-sixth day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35079-O L.DESILETS.35079 Deputy Attorney General.Gallant Paint Ltd.Gallant Paint Ltd.Peinture Gallant Ltée Peinture Gallant Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.C.LaRi- Province of Quebec, represented by Mr.C.chelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, LaRichelière, in conformity with section 2, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the quinze mai 1953, constituant en corporation: fifteenth day of May 1953, incorporating: René René Sénécal, C.A., J.-Hector Gallant, commer- Sénécal, C.A., J.-Hector Gallant, merchant, çant, Jean-Paul St-Louis, avocat, tous des cité Jean-Paul St-Louis, advocate, all of the city et district judiciaire de Montréal, pour les objets and judicial district of Montreal, for the following suivants : pu rposes : Manufacturer et faire le commerce de pein- To manufacture and deal in paints, under tures, sous le nom de \"Gallant Paint Ltd\" \u2014 the name of \"Gallant Paint Ltd\" \u2014 \"Peinture \"Peinture Gallant Ltée\", avec un capital de Gallant Ltée\", with a capital of $75,000 divided $75,000 divisé en 300 actions ordinaires de $100 into 300 common shares of $100 each and 450 chacune et en 450 actions privilégiées de $100 preferred shares of $100 each, chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company shall be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, in the judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le Dated at the office of the Attorney General, quinze mai 1953.the fifteenth day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35079-O \u2022 L.DÉSILETS.35079 Deputy Attorney General.Guaranty Outfitting Co.Guaranty Outfitting Co.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.C.La- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre Richclière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second du vingt-deuxième jour de mai 1953, constituant day of May, 1953, incorporating: Louis Orens-en corporation: Louis Orenstein, avocat, d'Outre- tein, advocate, of Outremont, Bernard Dia-mont, Bernard Diamond, avocat, Gilbert Ho- mond, advocate, Gilbert Howard, merchant, ward, marchand, tous deux de la cité de Montréal, both of the city of Montreal, all in the judicial tous du district judiciaire de Montréal, pour les district of Montreal, for the following purposes: objets suivants: Faire le commerce de vêtements, meubles, To deal in clothing, furniture, furnishings, fournitures, sous le nom de \"Guaranty Outfitting under the name of \"Guaranty Outfitting Co.\", Co.\", avec un capital de $15,000 divisé en 100 with a capital stock of $15,000.divided into 100 actions priviligiées de $100 chacune et 50 actions preferred shares of $100.each, and 50 common ordinaires de $100 chacune.shares of $100.each.Le siège social Vie la compagnie sera à Montréal, The head office .of the Company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 195S, Vol.86, No.26 2093 Daté du bureau DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.¦¦¦nMMMMMHMMMMIMMMMMNN 2096 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 L'Harmonie d'Alma Incorporée Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi dés compagnies de Québec, il a été accordé p ir le Lieutenant-gouverneur de la province tie Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettre» patentes, en date du vingt-trois mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: G.-Martial Langlois, .1.-Claude Sénéchal, d'Alma, et J.Marcel Tremblay, de Naudville, tous commis, dans le district judiciaire de Robérval, pour les objets suivants: Formation d'un corps de musique pour fin éducative, récréative et patriotique, sous le nom de \"L'Harmonie d'Alma Incorporée\".Le siège social de la corporation sera à Saint-Joseph-d'Alma, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1953.L'Assistant-procureur général.35079-o L.DÉSILETS.McCord Auto Company Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de mai 1953, constituant \u2022m corporation: Louis Feigenbaum, avocat, de Ville Si-Laurent, Hyman Solomon, avocat, AI or-ris Shuter, comptable, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles, pièces d'automobiles, machinerie, instruments, sous le nom de \"McCord Auto Company Incorporated\", avec un capital de $40,000 divisé en 80 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 320 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-huitième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Mercury Fur Inc.Avis est donné qu'en vertu de la permière partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représente par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour de mai 1953, constituant en corporation: Isidore Steinberg, fourreur, Esther Losbinsky Steinberg, épouse séparée de biens dudit Isidore Steinberg, Edmond-Joseph Belair, fourreur, Noella Hétu Belair, épouse séparée de biens dudit Edmond-Joseph Belair, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de fourrures, vêtements et articles vestimentaires, marchandises sèches, sous le nom de \"Mercury Fur Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé eu 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le .siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.L'Harmonie d'Alma Incorporée Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of May 1953, to incorporate a corporation without share-capital: G .-Martial Langlois, J.Claude Sénéchal, d'Alma, and J.-MarcelTremblay, of Naudville, all clerks, in the judicial district of Roberval, for the following purposes: The formation of a musical group for educative, recreative and patriotic purposes, under the name of \"L'Harmonie d'Alma Incorporée\".The head office of the corporation shall be at Saint-Joseph-d'Almu, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third dav of Mav 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.McCord Auto Company Incorporated Notice is heregy given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenthave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière.in conformitv sith section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth day of May, 1953, incorporating: Louis Feigenbaum, advocate, of Vi'le St.Laurent, Hyman Solomon, advocate, Morris Shuter, accountant, of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in automobiles, automobile parts, machinery, implements, under the name of \"McCord Auto Company Incorporated\", with a capital stock of $40,000.divided into 80 common shares of the par value of $100.each, and 320 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Mercury Fur Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth day of May, 1953, incorporating: Isidore Steinberg, furrier, Esther Loshinsky Steinberg, wife separate as to property of the said Isidore Steinberg, Edmond-Joseph Belair, furrier, Noella Hétu Belair, wife separate as to property of the said Edmond-Joseph Belair, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers, in furs, clothing and wearing apparel and dry goods, under the name of \"Mercury Fur Inc.\", with a capital stock \"of $40,000.divided into 200 common shares of a par value of $100 each, and 200 preferred shares of a par value of 8100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2097 Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-huitième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.M.Nudelman and Company Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941.des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de mai 1953, constituant en corporation : Horace Friedman, Isidore Grcen-liauiii, Michael Drazner, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, fabriquer, traiter, importer, exporter et généralement faire le commerce de textiles, menus objets et garnitures pour tailleurs, sous le nom de \"M.Nudelman and Company Incorporated\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 423 rue Mayor, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Normandie Bag & Novelty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de mai 1953, constituant en corporation: Harry Colton, manufacturier, Frances Furman, fille majeure, secrétaire, Anne Colton, ménagère, épouse séparée de biens dudit Harry Colton, tous des cité et district judiciaire de Montféal, pour les ogjets slivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de nouveautés et articles de fantaisie, sous le nom de \"Normandie Bag & Novelty Co.\", avec un capital de $100,000 divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et 7,000 actions privilégiées de $10 ohacune.Le siège social de la compagnie sera à 6586 avenue Papineau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Ouimet, Beaugrand, Boulay & Associés Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à Pzrticle 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1953, constituant enicorporation : Robert Ouimet, pharmacien, Florent Beaugrand, contramaître, Jean-Noël Boulay, comptable, tous de la ville d'Acton Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Agir comme agent d'affaires pour l'achat et ' la vente de fonds de commerce et de toutes sortes de biens meubles et immeubles et pour l'orga- Dated at the office ôf the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS.35079-o Deputy Attorney General.M.Nudelman and Company Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province df Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of May, 1953, incorporateing: Horace Friedman, Isidore Greenbaum, Michael Drazner, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, fabricate, process, import, export and generally deal in textiles, small wares and tailors trimmings, under the name of \"M.Nudelman and Company -Incorporated\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the Company will be at 423 Mayor Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May,- 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.- Normandie Bag & Novelty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of May, 1953, incorporating: Harry Colton, manufacturer, Frances Furman, spinster, secretary, Anne Colton, housewife, wi/e separate as to property of the said Harry Colton, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of novelties and fancy articles, under the name of \"Normandie Bag & Novelty Co.\", with a capital stock of $100,000.divided into 3,000 common shares of $10.each, and 7,000 preferred shares of $10.each.The head office of the Company will be at 6586 Papineau Ave, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o - Deputy Attorney General.Ouimet, Beaugrand, Boulay & Associés Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, Chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of May 1953, incorporating : Robert Ouimet, druggist, Florent Beaugrand, foreman, Jean-Noël Boulay, accountant, all of the town of Acton Vale, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To act as business agents in the buying and selling of business concerns and of all kinds of moveable and immoveable property and for the 2098 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 195S, Tome 86, N° 26 nisation, et l'administration d'entreprises commerciales et industrielles; faire et exercer toutes ou aucune des opérations d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Ouimet, Beaugrand, Boulay & Associés Inc.\", avec un capital de 893,000, divisé en 300 actions ordinaires de $10 chacune, et en 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Acton Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.organization and administration of commercial and industrial undertakings; carry out the operations of general contractors in construction work, under the name of \"Ouimet, Beaugrand, Boulay & Associés Inc.\", with a capital of §93,000, divided into 300 common shares of $10 each, and 900 preferred shares-of $100 each.The head office of the company shall be at Acton Vale, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 .Deputy Attorney General.Park Plaza Restaurant Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la >rovince de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-trois mai 1953, constituant en corporation: Robert Harold Earle Walker, c.r., Roger-Louis Beaulieu, tous deux de la cité de Montréal, George Anthony Allison, William Tetley, tous deux de Ville Mont-Royal, tous avocats, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"Park Plaza Restaurant Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1953.L'Assistant-procureur général, 25079 L.DÉSILETS.Park Plaza Restaurant Limited Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of May, 1953, incorporating; Robert Harold Earle Walker, Q.C., Roger-Louis Beaulieu, both of the city of Montreal, George Anthony AUison, William Tetley, both of the town of Mount Royal, all advocates, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Park Plaza Restaurant Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1953.L.DÉSILETS, 25079-o Deputy Attorney General.P.Chicoine Automobiles, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du seize mai 1953, constituant en corporation: Philias Chicoine, Dollard Chicoine, Roger Chicoine, Jean-Paul Chicoine, garagistes et débosseurs, et Rita Chicoine, fille majeure, sténographe, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de véhicules, exploiter des garages, sous le nom de \"P.Chicoine Automobiles, Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.P.Chicoine Automobiles, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebeo, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S'Q.1941, bearing date the sixteenth day of May 1953, incorporating: Philias Chicoine, Dollard Chicoine, Roger Chicoine, Jean-Paul Chicoine, garage-keepers and mechanics, and Rita Chicoine, spinster, stenographer, all of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To deal in all kinds of vehicles, and operate garages, under the name of \"P.Chicoine Automobiles, Inc.\", with a capital of $100,000 divided into 1,000 common shares of a par value of $100 each.The head office of the Company shall be at Sherbrooke, in the judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of May 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Plomberie & Chauffage Frigon Plomberie & Chauffage Frigon Plumbing & Heating Inc.Plumbing & Heating Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent habe been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, 'Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2099 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-six mai 1953, constituant en corporation: Jean Gauthier, avocat, Jean-Jules ,Rufiange, Fernand-E.Leblanc, comptables agréés, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le métier de plombiers, couvreurs, entrepreneurs plombiers et couvreurs, entrepreneurs chauffage, sous le nom de \"Plomberie & Chauffage Frigon Plumbing & Heating Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 4,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1953.«.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.Richer & Frère Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1953, constituant en corporation* Eugène Richer, industriel, Anita Reynolds-Richer, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Eugène Richer, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, Guy Richer, commerçant, tous de la cité de Sa-laberry-dc-Valleyfield, district judiciaire de Beau-harnois, pour les objets suivants: ¦ D'exercer et exploiter le commerce d'eaux gazeuses et minérales, sous le nom de \"Richer & Frère Ltée\", avec un capital de $75,000 divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sala-berry-de-Val ley field, district judiciaire de Bcau-harnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Service Social de l'Enfance et de la Famille,.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du seize mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: M.l'abbé Gérard Gariépy, chancelier du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Louis-Auguste Dupuis, notaire, Champlain Perreault, agronome, tous trois de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sarto Sirois, médecin, Jean-Paul Bérubé, avocat, de Rivière-du-Loup, tous cinq du district judiciaire de Kamou-raska, et Georges Hébert, notaire de Montmagny, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants: Aider la famille et travailler à son relèvement moral et social, sous le nom de \"Service Social de l'Enfance et de la Famille\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, district judiciaire de Ka-mouraska.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1953.L'Assi s tan t-p rocu reu r général, 35079-o L.DÉSILETS.R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-sixth day of May, 1953 incorporating: Jean Gauthier, advocate, Jean-Jules Rufiange, Fernand E.Leblanc, chartered accountants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade of plumbers, roofers, ¦ contracting plumbers and roofers, heating contractors, under the name of \"Plomberie & Chauffage Frigon Plumbing & Heating Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Richer & Frère Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-second day of May, 1953 incorporating: Eugène Richer, industrialist, Anita Reynolds-Richer, housewife, wife separate as to property by marriage contract, of the said Eugène Richer, and duly authorized by the latter for these presents, Guy Richer, dealer, all of the city of Salaberry-de-Valleyfield, judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To operate the business of and deal in gazeous and mineral waters under the name of \"Richer & Frère Ltée\", with a capital stock of $75,000 divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Salaberry-de-Valleyfield judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Service Social de l'Enfance et de la Famille Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixteenth day of May, 1953, to incorporate as a corporation, without share capital: Father Gérard Gariépy, chancellor of the diocese of Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Louis-Auguste Dupuis, notary, Cham-plain Perreault, agronomist, all three of Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sarto Sirois, physician, Jean-Paul Bérubé, advocate, of Rivière-du-Loup, all five of the judicial district of Kamouraska, and Georges Hébert, notary, of Montmagny, judicial district of Montmagny, for the following purposes: To help and work for the moral and social uplift of child and family welfare, under the name of \"Service Social de l'Enfance et de la Famille\".The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Sainte-Anne-de-la-Pocatière, judicial district of Kamouraska.Dared at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General. 2100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 Shawinigan Minerals Ltd.Shawinigan Minerals Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.C.La- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth vingt-huit mai 1953, constituant en corporation: day of May, 1953, incorporating: Louis Orensein, Louis Orenstein, avocat, de la cité d'Outremont, advocate, of the city of Outremont, Bernard Bernard Diamond, avocat, Larry Smith, comp- Diamond, advocate, Larry Smith, accountant, table, et Gilbert Howard, marchand, tous de la and Gilbert Howard, merchant, all of the city cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, of Montreal, judicial district of Montreal, for the pour les objets suivants: following purposes: Faire le commerce de tous genres de niacin- The deal in ail types of machinery as well as nerie ainsi que de minéraux et de métaux soit minerals and metals whether new or used, under neufs ou usagés, sous le nom de \"Shawinigan the name of \"Shawinigan Minerais Ltd.\", with Minerals Ltd.\", avec un capital de $40,000, a capital stock of $40,000, divided into 3,000 divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune common shares of $10 each, and 100 preferred et 100 actions privilégiées de $100 chacune.shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General vingt-huit mai 1953.this twenty-eighth day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35079 L.DÉSILETS.25079-o Deputy Attorney General.Simard & Frères, Cie Ltée, (1953) Simard & Frères, Cie Ltée, (1953) Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.C.La- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, conformément à l'arrticle 2, chapitre Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date 276, R.S.Q., 1941-, bearing date the twenty-first du vingt et un.mai 1953, constituant en corpo- day of May, 1953, incorporating: Raymond ration : Raymond Fortier, comptable agréé, Yves Fortier, chartered accountant, Yves Royer, Royer, Pierre Bienjonetti, avocats, tous des cité Pierre Bienjonetti, advocates, all of the city and et district judiciaire de Québec, pour les objets judicial district of Quebec, for the following su i vants : pu rposes : Agir comme entrepreneur pour travaux de To operate as a contractor for construction or construction ou de génie, sous le nom de \"Simard engineering work, under the name of \"Simard & Frères, Cie Ltée, (1953)\", avec un capital de & Frères, Cie Ltée, (1953), with a capital stock $1,075,000, divisé en 250 actions ordinaires de of $1,075,000, divided into 250 common shares $100 chacune, 4,500 actions privilégiées classe of $100 each, 4,500 preferred class \"A\" shares \"A\" de $100 chacune, 2,000 actions privilégiées of $100 each, 2,000 class \"B\" preferred shares classe \"B\" de $100 chacune et 4,000 actions of $100 each and 4,000 class \"C\" privilégiées classe \"C\" de $100 chacune.preferred shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Amos, The head office of the company will be at district judiciaire d'Abitibi.Amos, judicial district of Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le vingt Dated at the office of the Attorney General, et un mai 1953.this twenty-first day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35079-o L.DÉSILETS.35079 Deputy Attorney General.Ste Foy Construction Ltée\u2014Ltd.Ste Foy Construction Ltée\u2014Ltd.Avis est donné -qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, représenté par M.C.La- Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du 276, S.R.Q., 1941, hearing date the twenty-vingt-huit mai 1953, constituant en corporation: eighth day of May, 1953, incorporating: André André Reny, entrepreneur, Denise Godbout- Reny, contractor, Denise Godbout-Reny, house-Reny, ménagère, épouse séparée de biens dudit wife, wife separate as to property of the said André Reny, tous deux de Ste-Foy, Gérard André Reny, both of Ste-Foy, Gerard Lauzier, Lauzier, comptable agréé, de Québec, tous du chartered accountant, of Quebec, all of the district judiciaire de Québec, pour les objets judicial district of Quebec, for the following suivants: purposes: Exercer l'industrie d'entrepreneurs généraux, To carry on the business of general contrac- sous le nom de \"Ste Foy Construction Ltée\u2014Ltd.\", tors, under the name of \"Ste Foy Construction avec un capital de $90,000 divisé en 900 actions Ltée\u2014Ltd.\", with a capital stock of $90,000 de $100 chacune.divided into 900 shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à 80, rue The head office of the company will be at Saint-Jean Bosco, Ste-Foy, district judiciaire de 80» Saint-Jean Bosco St., Ste-Foy, judicial disQuébec, trict of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, June 27th, 1968, Vol.85, No.26 2101 Daté du bureau du Procureur général le vingt-hui mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.Superior Automobiles Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-huit mai 1953, constituant en corporation: Léo Joseph Soucie, vendeur, Bernard Diamond, avocat, de la cité de Montréal, Louis Orenstein, avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de véhicules-moteurs; et exploiter des garages publics et privés, sous le nom de \"Superior Automobiles Ltd.\", avec un capital de $30,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Sylvio Marceau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1953, constituant en corporation: Jean-Paul Lambert, Jean St-Jean, comptables, Germaine Lacharité, tous trois de la cité de Montréal, Hélène Terriault, de Verdun, ces deux dernières sténographes, célibataires, et Clément Demers, comptable, de Laprairie, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs de pompes funèbres, embaumeurs, directeurs de funérailles, sous le nom de \"Sylvio Marceau Inc.\" Le capital-actions de la compagnie ett divisé en 5,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 1750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Superior Automobiles Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941.bearing date the twenty-eighth day of May, 1953, incorporating: Léo-Joseph Soucie, salesman, Bernard Diamond, advocate, of the city of Montreal, Louis Orenstein, advocate, of the city of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers, dealers in motor vehicles, and to operate public and private garages, under the name of \"Superior Automobiles Ltd.\", with a capital stock of $30,000, divided into 150 common shares of $100 each, and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Sylvio Marceau Inc.Notice is given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of May 1953, incorporating: Jean-Paul Lambert, Jean St-Jean, accountants, Germaine Lacharité, all three of the city of Montreal, Hélène Terriault, of Verdun, the two latter, stenographers, spinsters, and Clément Demers, accountant, of Laprairie, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as morticians, embalmers, undertakers, under the name of \"Sylvio Marceau Inc.\" The capital stock of the company is divided into 5,000 shares without nominal or par value and 1750 preferred shares of $100 each.The head office of the company shall be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of May 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.The Aylmer and South Hull Humane Society La Société Protectrice des Animaux d'Aylmcr et de Hull-Sud Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du seize mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: John R.Kelso, Victor J.Layton, Koenraad Nyenhuis, employés civils, Rodolphe Maltais, inspecteur régional, d'Aylmer, Thomas g.Mayburry, fermier, Harold C.Linkletter, The Aylmer and South Hull Humane Society La Société Protectrice des Animaux d'Aylmer et de Hull-Sud Notice is hereby given that under the Provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelièfe, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixteenth day of May, 1953, incorporating without share capital: John R.Kelso, Victor J.Layton, Koenraad Hyenhuis, Civil Servants, Rodolphe Maltais, regional inspector, of Aylmer, Thomas G.Mayburry, farmer, 2102 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 86, N° 26 avocat, d'Aylmer Est, tous du district judiciaire de Hull, pour les objets suivants: Promouvoir et développer le sentiment humain du public et fournir des moyens effectifs pour prévenir la cruauté envers les animaux et les oiseaux, sous le nom de \"The Aylmer and South Hull Humane Society\" \u2014 \"La Société Protectrice des Animaux d'Aylmer et de Hull-Sud\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de S 10,000.Le siège social de la corporation sera à Aylmer, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1953.L'Assistant-prxcurcur général, 35079 L.DÉSILETS.Harold C.Linkletter, lawyer, of Aylmer East, all of the judicial district of Hull, for the To promote and develop public humane sentiment and to provide effective means for the prevention of cruelty to animals and birds, under the name of \"The Aylmer and South Hull Humane Society\" \u2014 \"La -Société Protectrice des Animaux d'Aylmer et de Hull-Sud\".following purposes: The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Aylmer, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 3507Ô-O Deputy Attorney General.The Hurstwood Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vi îgt-trois mai 1953, constituant en corporation: Harold S.Freeman, Abraham H.J.Zaitlin, avocats, et Theresa Murray, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"The Hurstwood Corporation\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.The Linton Apartments (1953) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patentes en date du vingt-cinq mai 1953, constituant en corporation: John Fitzwilliam Stairs, avocat, de la cité de Westmount, Patrick Emmet Kierans, John Brooke Claxton, Albert Bronson Culver, avocats, James Evelyn Mitchell, avocat et conseil eTi loi de la Reine, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"The Linton Apartments (1953) Limited\", avec un capital de SI,000,000, divisé en 999,900 actias catégorie A d'une valeur au pair de $1 chacune et 100 actions catégorie B d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Universal General Supply Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a The Hurstwood Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the LieutenantrGovernor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of May, 1953, incorporating: Harold S.Freeman, Abraham H.J.Zaitlin, advocates, and Theresa Murray, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with a certain immoveable property, under the name of \"The Hurstwood Corporation\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of $100 each, and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of May,- 1953.L.DÉSILETS, 35079-9 Deputy Attorney General.The Linton Apartments (1953) Limited Notice is hereby given that under Part I oj the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of'Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fifth day of'May, 1953, incorporating: John Fitzwilliam Stairs, advocate, of the city of West-mount, Patrick Emmet Kierans, John Brooke Claxton, Albert Bronson Culver, advocates, James Evelyn Mitchell, advocate and Queen's Counsel, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes : To acquire and deal with a certain immoveable property, under the name of \"The Linton Apartments (1953) Limited\", with a capital ctock of $1,000,000, divided into 999,900 Class A Shares of the par value of $1 each and 100 Class B Shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.Universal General Supply Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2103 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté, par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-six mai 1953, constituant en corporation: Albert Hougui Saleh.Maurice Albert Saleh, Harone Meer Kattan, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de textiles, produits alimentaires et papier-journal, sous le nom de \"Universal General Supply Company Inc.\", avec un capital de §100,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 * L.DÉSILETS.Urbis Agency Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-huit mai 1953, constituant en corporation: Gustavo D'Errico, agent, Giuseppe D'Erri-co, bourgeois, Clara D'Errico, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général 'd'exportation et d'importation, sous le nom de \"Urbis Agency Corporation\", avec un capital de $15,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 509 Bélanger Est, Montréal, distirct judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Vitrerie Mont Royal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1953, constituant e î corporation: Victor-Albert Daoust, gérant, André Daoust caissier, tous deux de Verdun, et Ubald Cyr, gérant, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du verre, de ses produits et sous-produits; faire affaires comme constructeur et entrepreneurs, sous le nom de \"Vitrerie Mont Royal Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, et en 360 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of May, 1953, incorporating: Albert Hougui Saleh, Maurice Albert Saleh, Harone Meer Kattan, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers in textiles, food products, newsprint, under the name of \"Universal General Supply Company Inc.\", with a capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each, and 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth day of May, 1953.L.DÊSLLETS, 25079-o Deputy Attorney General.Urbis Agency Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth day of May, 1953, incorporating: Gustavo d'Érri-co, agent, Giuseppe D'Errico, gentleman, Clara D'Errico, secretary, single, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general exporting and importing business, under the name of \"Urbis Agency Corporation\", with a capital stock of $15,000, divided into 150 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 509 Bélanger East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-eighth day of May, 1953.L.DÊSLLETS, 35079-o Deputy Attorney General.Vitrerie Mont Royal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of May 1953, incorporating: Victor-Albert Daoust, manager, André Daoust, cashier, both of Verdun, and Ubald Cyr, manager, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in glass, also the products and by-procduts thereof; to carry on business as contractors and builders, under the name of \"Vitrerie Mont Royal Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of a par value of $100 each, and 360 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-second day of May 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Vug Mining and Development Corporation (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a Vug Mining and Development Corporation .(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, 2104 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de mai 1953, constituant en corporation: Milton L.Klein, avocat, Irwin B.Blond, notaire public, Arthur D.Ruby, Lewis J.Manolson, comptables et Ethel Schwisberg, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Vug Mining and Development Corporation\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $3,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of May, 1953, incorporating: Milton L.Klein, advocate, Irwin B.Blond, notary public, Arthur D.Ruby, Lewis J.Manolson, accountants, and Ethel Schwisberg, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, and deal with the same, under the name of \"Vug Mining and.Development Corporation \"(No Personal Liability), with a capital stock of $3,000,000, divided into 3,000,000 shares of $1.each.The shareholders shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for it s shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twnety-first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General Whistle Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1953, constituant en corporation: Art.-A.Métivier, agent d'assurance, Cécile Cha-rest-Métivier, ménagère, Lionel Roussin, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec.jiour les objets suivants: Faire le commerce de matières premières, fournitures et accessoires pour ou servant aux embouteiHeurs d'eaux gazeuses, sous le nom de \"Whistle Products Inc.\", avec un capital de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L' DÊSLLETS.Whistle Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-first day of May, 1953, incorporating: Art.A.Métivier, insurance agent, Cécile Cha-rest-Métivier, housewife, Lionel Roussin, accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in raw materials, furnishings and accessories for or to be used in the bottling of gaseous waters, under the name of \"Whistle Products Inc.\", with a capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.11997-53) Afco Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 3 juin 1953, à la compagnie \"Afco Ltd.\", augmentant son capital de $40,000 à $200,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1600 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 3 juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.Supplementary Letters Patent (A.G.11997-53) Afco Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of June, 1953.were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Afco Ltd.\", increasing its capital from $40,000 to $200,000: the additional capital stock being divided into 1600 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 3rd day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2105 (P.G.10879-53) Albion Textile Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur ,repér-senté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 27e jour de mai 1953 à la compagnie \"Albion Textile Company Limited\", augmentant son capital de 849,500 à 899,500: le capital-actions additionnel étant divisé en 500 actions privi-lébiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 27c jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.(P.G.11131-53) Babin Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il z été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"Babin Charlebois Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 28 avril 1949, en celui de \"Babin Automobile Ltée\".Daté du bureau du Procureur général le 26 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.(P.G.12083-53) Brandon Shirt Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la * province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du trois juin 1953, à la compagnie \"Brandon Shirt Manufacturing Co.Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 3 avril 1946, 1° portant soh capital de $25,000 à $100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 350 actions ordinaires de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune; 2° changeant son nom en celui de \"Brandon Shirt Mfg.Co.Ltd.\"; 3° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le 3 juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.(P.G.10140-53) Davie Brothers Ltd.Avis est donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q., 1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du cinq juin 1953, à la compagnie \"Davie Brothers Ltd.\", a) augmentant son capital de $200,000 à $240,- (A.G.10879-53) Albion Textile Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Albion Textile Company Limited\", increasing its capital from $49,500 to $99,500: the additional capital stock being divided into 500 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 27th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.(A.G.11131-53) Babin Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, S.R.Q., 1941, chapter 276, bearing date the twenty-sixth day of May, 1953, changing the name of company \"Babin Charlebois Limitée\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated April 28, 1949, into that of \"Babin Automobile Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(A.G.12083-53) Brandon Shirt Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, bearing date the third day of June, 1953, to the company \"Brandon Shirt Manufacturing Co.Ltd.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated April 3, 1946: 1.carrying its capital stock from $25,000 to $100,000: the additional capital stock being divided into 350 common shares of $100 each and into 400 preferred shares of $100 each; 2.changing its name into that of \"Brandon Shirt Mfg.Co.Ltd.\"; 3.extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this 3rd day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(A.G.10140-53) Davie Brothers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, bearing date the fifth dav of June, 1953, to the company \"Davie Brothers Ltd.\", a) increasing its capital stock from $200,000 to $240,000: the additional capital stock being divided into 400 common 2106 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 000: le capital-actions additionne] étant divisé en 400 actions ordinaires de 8100; b) modifiant une des dispositions des lettres patentes de ladite compagnie.Daté du bureau du Procureur général, le 5 juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.(P.G.7518-53) Inter-City Construction Ltée Inter-City Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du trente mai 1953, à la compagnie \"Inter-Cité Construction Ltée \u2014 Inter-City Construction Ltd.\", modifiant les privilèges attaché» à ces actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le 30 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.shares of $100; b) amending one of the provisions of the letters patent of the said company.Dated at the office of the Attorney General, this 5th day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(A.G.7518-53) Inter-City Construction Ltée Inter-City Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, bearing date the thirtieth day of May, 1953, to the company \"Inter-Cité Construction Ltée \u2014 Inter-City Construction Ltd.\", modifying the privileges attached to its preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, May 30th, 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(P.G.8455-52) La Compagnie du Téléphone Saguenay\u2014 Quebec Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du cinq juin 1953, à \"La Compagnie du Telephone Saguenay-Quebec\", portant de 360,000 à 450,000 le nombre des actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, et fixant à $2,250,000 la somme avec laquelle la compagnie continuera ses opérations.Daté du bureau du Procureur général le 5 juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.(P.G.11130-53) Park Securities Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 26e jour de mai 1953 changeant le nom de la compagnie \"Alexander & Associates (Quebec) Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 7 avril 1953, en celui de \"Park Securities Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 26e jour de mai 1953.L'Assistaût-procureur général, 35079 L.DÊSLLETS.(P.G.1608-47) Quebec Labrador Development Company Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec (A.G.8455-52) La Compagnie du Téléphone Saguenay\u2014 Quebec Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, pursuant to section 2 oi the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, bearing date the fifth day of June 1953, to \"La Compagnie du Telephone Saguenay-Quebcc\", increasing from 360,000 to 450,000 the number of common shares without nominal or par value, and fixing at $2,250,000 the amount with which the company shall continue to operate.Dated at the office of the Attorney General, June 5th, 1953.L: DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(A.G.11130-53) Park Securities Ltd.* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, changing the name of the company \"Alexander & Associates (Quebec) Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated April 7, 1953, to that of \"Park Securities Ltd.\" v Dated at the office of the Attorney General, the 26th day of May, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney General.(A.G.1608-47) Quebec Labrador Development Company Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Minong Companies' Act, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1963, Vol.85, No.26 2107 et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi des compagnies de Québec, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du trente mai 1953, à la compagnie \"Quebec Labrador Developemcnt Company Limited\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi des compagnies minières de Québec, portant son capital de $5,000,000 à $7,500,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,500,000 actions ordinaires de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 30 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.(P.G.12071-53) Sanatorium Prévost Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par, M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 se ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du premier juin 1953, à la corporation \"Sanatorium Prévost'', constituée en vertu de la troisième partie de ladite loi, par lettres patentes datées du 4 mai 1945, étendant ses pouvoirs en portant de $900,000 à $3,000,000 la valeur de» immeubles que pourra désormais posséder ladite corporation.Daté du bureau du Procureur général le 1er juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35079-o L.DÉSILETS.(P.G.7749-53) St.Francis Rod & Gun Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 10e jour de juin 1953, pour confirmer un règlement de la corporation \"St-Francis Rod & Gun Club Inc.\", constituée en corporation sans capital-actions en vertu des dispositions de l'article 214 de ladite Loi par lettres patentes en date du 1er mars 1938, pourvoyant à la création d'un capital divisé en 5,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie est à Port Lewis, comté de Huntingdon, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, ce 10e jour de juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35079 L.DÉSILETS.(P.G.1968-53) The Swiss Hut Bar-B-Q- Limited La Hutte Suisse BarrB-Q- Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du trente mai 1953, and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented liy Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Quebec Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 276 bearing date the thirtieth day of May 1953, to the company \"Quebec Labrador Developement Company Limited\" (No Personal Liability), incorporated under ihe said Quebec Mining Companies' Act, increasing its capital from $5,000,000 to $7,500,000: the additional share-capital being divided into 2,500,000 common shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, May 30th, 1953./ L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(A.G.12071-53) Sanatorium Prévost >- Notice is hereby given that in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chaDter 276, bearing date the first day of June 1953, to the corporation \"Sanatorium Prcvost\", incorporated under Part III of said Act, by letters patent dated May 4th, 1945, extending its powers by increasing from $900,000 to $3,000,000 the value of immoveable preperties which the said corporation may hereafter hold.Dated at the office of the Attorney General, the first day of June 1953.L.DÉSILETS, 35079 Deputy Attorney General.(P.G.7749-53) St.Francis Rod & Gun Club Inci Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent, bearing date the 10th day of June, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to confirm a by-law of \"St.Francis Rod & Gun Club Inc.\", a corporation incorporated without share capital under the provisions of section 214 of the said Act by letters patent dated March 1st, 1938, providing for the creation of a capital divided into 5,000 shares without nominal or par value.The principal place of business of the company is at Port Lewis, county of Huntingdon, in the judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this 10th day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35079-o Deputy Attorney general.(A.G.1968-53) The Swiss Hut Bar-B-Q- Limited La Hutte Suisse Bar-B-Q- Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, S.R.Q., 1941, chapter 276, bearing date the thirtieth\" day of May, 1953, to the'eompany \"The Swiss Hut Bar-B-Q Limited \u2014 La Hutte Suisse Bar-B-Q » 2108 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 195S, Tome 85, N° 26 à la compagnie \"The Swiss Hut Bar-B-Q Limi- Limitée\", carrying its capital stock from $20,000 ted\u2014La Hutte Suisse Bar-B-Q Limitée\", por- to $100,000: the additional capital stock being tant son capital de $20,000 à $100,000: le capital- divided into 800 common shares of $100 each, actions additionel étant divisé en 800 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 30 Dated at the office of the Attorney General, mai 1953.this thirtieth day of May, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35079-o L.DÉSILETS.35079 Deputy Attorney general.Arrêtés en Conseil Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 738 Number 738 Québec, le 18 juin 1953.Quebec, June 18, 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Section \"A\" Part \"A\" Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating aux métiers de boulanger et distributeur de to bakers and bread, cake and pastry deliverers pain, gâteaux et pâtisserie dans la région de in the district of Trois-Rivières.Trois-Rivières.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de boulanger et distributeur de pain, gâteaux et pâtisserie dans la région de Trois-Rivières, rendue obligatoire par le décret numéro 305 du 23 février 1938, amendé par les arrêtés numéros 489 du 1er février 1940, 2747 et 3057 des 15 octobre et 12 novembre 1942, 1693 du 4 mai 1945, 1660 du 10 mai 1946, 689-C et 1907-A des 30 avril et 19 novembre 1947, 1132-A du 1er septembre 1948, 883-E du 11 août 1949 et 67-B du 31 janvier 1952, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender ledit décret: Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 9 mai 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que ledit décret, numéro 305, soit modifié comme suit: Le paragraphe \"a\" de l'article II est remplacé par le suivant: \"a) Boulangers, pâtissiers: Compagnons: par semaine 1er boulanger.$48.00 1er pâtissier.48.00 2ème boulanger.44.00 2ème pâtissier.44.00 3ème boulanger et les compagnons suivants.41.00 3ème pâtissier et les compagnons suivants.41.00 Apprentis: 1ère année.24.00 2ème année.28.00 3ème année.32.00\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) Le Grenier suppléant du Conseil Exécutif, 35096-o C.LARICHELIÈRE.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the bakers and bread, cake and pastry deliverers in the district of Trois-Rivières, rendered obligatory by the decree number 305 of February 23, 1938, and amended by Orders 489 of February 1, 1940, 2747 and 3057 of October 15 and November 12, 1942, 1693 of May 4, 1945, 1660 of May 10, 1946, 689-C and 1907-A of April 30 and November 19, 1947, 1132-A of September 1, 1948, 883-E of August 11, 1949 and 67-B of January 31, 1952, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree, as amended; Whereas the said petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of May 9, 1953; Whereas no objection was made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Prime Minister of Labour: That the said decree, number 305, be amended as follows: Subsection \"a\" of section II is replaced by the following: \"a) Bakers, pastry-cooks: Journeymen: per week 1st baker.$48.00 1st pastry-cook.48.00 2nd baker.44.00 2nd pastry-cook.44.00 3rd baker and other journeymen.41.00 3rd pastry-cook and other journeymen.41.00 Apprentices: 1st year.24.00 2nd year.28.00 3rd year.32.00\" (Document \"A\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 35096-o Acting Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 195S, Vol.85, No.26 2109 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 738 ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 738 Québec, le 18 juin 1953.Quebec, June 18, 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Section \"B\" Part \"B\" Concernant la prolongation du décret relatif à Concerning an extension of the decree relating l'industrie de la confection pour dames dans la to the ladies cloak and suit industry in the province de Québec.province of Quebec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que le décret numéro 2375 du 11 septembre 1937 et ses amendements, relatif à l'Industrie de la Confection pour Dames dans la province de Québec, soit prolongé jusqu'au 30 juin 1954.(Document \"B\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 35096-o Greffier suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTLF It is ordered, on the recommendation of the Honourable Prime Minister: That the decree Number 2375 of September 11, 1937, as amended, relating to the Ladies Cloak and Suit Industry in the Province of Quebec, be extended until June 30, 1954.(Document \"B\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 35096-o Acting clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 738 Number 738 Québec, le 18 juin 1953.Quebec, June 18, 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Section ,(C\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que le décret numéro 411 du 17 avril 1952 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de la costruction dans la région de Montréal, soit prolongé jusqu'au 1er octobre 1953.(Document \"C\" annexé à l'arrêté) C.LARICHELIÈRE, 35096-o Greffier suppléant du conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 738 Québec, le 18 juin, 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"D\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie du fer structural dans la province de Québec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que le décret numéro 890 du 28 août 1952, relatif à l'industrie du fer structural dans la province de Québec, soit prolongé jusqu'au 1er septembre 1953.(Document \"D\" annexé à l'arrêté).C.LARICHELIÈRE, 35096-o Greffier suppléant du Conseil Exécutif.Part \"C\" Concerning an extension of the decree relating to the construction industry and trades in the district of Montreal.It is ordained, on the recommendation of the Honourable Prime Minister, That the decree No.411 of April 17, 1952, as amended, relating to the construction industry and trades in the district of Montreal, be extended until October 1st, 1953.(Document \"C\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 35096-o Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 738 Quebec, June 18, 1953.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Part \"D\" Concerning an extension of the decree relating to the structural iron industry in the province of Quebec.It is otdered, on the recommendation of the Honourable Prime Minister, That the decree No.890 of August 28, 1952, relating to the structural iron industry in the province of Quebec, be extended until September 1st, 1953.(Document \"D\" annexed to the Order).C.LARICHELIÈRE, 35096-o Acting Clerk of the Executive Council. 2110 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 739 \u2022 _ Québec, le 18 juin 1953.t Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil ~Scctio7i \"D\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 504-B du 7 mai 1952, soit prolongé jusqu'au 1er octobre 1953, aux mêmes taux et conditions.C.LARICHELIÈRE, 35096-o Greffier suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 739 Québec, le 18 juin 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"E\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que lé droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal, établi en exécution du décret numéro 411 du 17 avril 1952, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1292-B du 15 décembre 1952, relativement à l'administration du décret numéro 890 du 28 août 1952, concernant l'industrie du fer structural dans la province de Québec, soit prolongé jusqu'au 1er septembre 1953, aux mêmes taux et conditions.C.LARICHELIÈRE, 35096-o Greffier suppléant du Conseil Exécutif.Département du Travail ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 739 Quebec, June 18, 1953.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Part \"D\" Concerning an extension of the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal.It is ordered, on the recommendation of the Honourable Prime Minister: That the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal, authorized by a by-law approved by Order in Council Number 504-B of May 7, 1952, be extended until October 1st, 1953, with the same rate and conditions.C.LARICHELIÈRE, 35096-o Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 739 Quebec, June 18, 1953.Present: 'The Lieutenant-Governor in Council.Part \"E\" Concerning an extension of the right to levy of the Buildings Trades Joint Committee of Montreal.It is ordered, on the recommendation of the Honourable Prime Minister: That the right to levy of the Buildings Trades Joint Committee of Montreal, formed under decree No.411 of April 17, 1952, authorized by by-law approved by Order in Council No.1292-B of December 15, 1952, as regards the administration of decree No.890 of August 28, 1952, concerning the structural iron industry in the Province of Quebec, be extended until September 1st 1953, with the same rate and conditions.C.LARICHELIÈRE, 35096-o Acting Clerk of the Executive Council.Department of Labour Avis d'approbation de règlements L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, établi en exécution du décret numéro 643 du 29 mai 1953 et dont le siège social est situé dans la cité de Montréal, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 739-A du 18 juin 1953.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o Notice of Approval of By-laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the constitution and general by-laws of the Retail Fur Trade Joint Committee of Montreal and District, established under decree No.643 of May 29, 1953, with head office in the city of Montreal, have been approved by Order in Council No.739-A of June 18, 1953.- GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 27, 1953.35096-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1958, Vol.85, No.26 2111 AVIS DE PRÉLÈVEMENT NOTICE OF LEVY L'honorable Antonio Barrette, ministre du The Honourable Antonio Barrette, Minister of Travail, donne avis par les présentes que le Co- Labour, hereby gives- notice that the Retail mite paritaire du commerce de détail de la four- Fur Trade Joint Committee of Montreal and rare de Montréal et du district, établi en exécu- District, formed under decree Number 643 of tion du décret numéro 643.du 29 mai 1953, May 29, 1953, has been authorized by a by-law a été autorisé par règlement approuvé par Par- approved by Order in Council number 739 of rêté en conseil numéro 739 du 18 juin 1953, June 18, 1953, part \"B\", in conformith with the section \"B\", le tout, d'accord avec les disposi- provisions of the Collective Agreement Act tions de la Loi de la convention collective (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 and amendments), to levy assessments upon the et amendements), à prélever des cotisations des professional employers, the artisans and the employeurs professionnels, des artisans et des sa- employees governed by the said decree, according Iariés assujettis audit décret, suivant la méthode to the method and rate hereinafter mentioned, et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation 1.Assessments La période de cotisation s'étend de la date de The period of levy extends from the date of publication du présent règlement dans la Gazette publication of this by-law in the Quebec Official officielle de Québec au 31 mars 1954: cette cotisa- Gazette to March 31, 1954; the levy shall be tion s'exerce comme ci-dessous mentionné: laid as follows: a) Les employeurs professionnels assujettis a) The professional employers governed by the audit décret numéro 643 doivent verser au said decree, number 643, shall pay to the Parity Comité paritaire une somme équivalente à Committee an amount equivalent to Yt of 1% % de 1% de leur liste de paye pour les salariés of their pay roll as regards employees governed assujettis audit décret.by the said decree.b) Les artisans assujettis audit décret numéro b) Artisans governed by the said decree, numb-643 doivent verser au Comité paritaire une somme er 643, shall pay to the Parity Committee an équivalente à Y de 1% du salaire établi dans le amount equivalent to }4 of 1% of the lowest décret pour le compagnon tailleur le moins ré- wages established in the decree for journeymen munéré, soit 864.80 par semaine.- tailors, namely 864.80 per week.c) Les salariés assujettis audit décret numéro c) Employees governed by the said decree, 643 doivent verser au Comité paritaire une number 643, shall pay to the Parity Committee somme équivalente à Y2 de 1% de leur rémunéra- an amount equivalent to Y2 of 1% of their remu-tion.neration.2.Mode de perception 2.Mode of collection En vue de faciliter la perception de ces cotisa- In order to facilitate the collection of these tions, le Comité paritaire met à la disposition des assessments, the Partiy Committee supplies the employeurs professionnels des formules de rapport professional employers with report forms on sur lesquelles doivent être indiqués tous les ren- which all particulars required by the said Parity seignements exigés par ledit Comité paritaire.Committee shall be indicated.Professional L'employeur professionnel doit compléter son employers shall complete their report and shall rapport, le signer et le faire parvenir au Comité sign and forward it to the Parity Committee paritaire à chaque mois.every month.L'employeur professionnel doit percevoir, à la Professional employers shall collect, at the fin de chaque semaine, au nom du Comité, le end of each week, in the name of the Committee, prélèvement imposé à ses salariés, au moyen the assessments owed by their employees by d'une retenue sur le salaire de ces derniers.means of a deduction from their pay.L'employeur professionnel doit transmettre Professional employers shall submit their son rapport mensuel au Comité paritaire le ou monthly report to the Parity Committee on or avant le 10 du mois suivant la date d'expiration before the 10th day of the month following the de la période pour laquelle il est exigible; ledit date of expiration of the period for which it is rapport doit être accompagné de la cotisation requirable; that report shall be sent together de l'employeur professionnel et des sommes with the assessments of professional employers payables au Comité paritaire par ses salariés, and those of their employees.The Committee Le comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation may have such reports sworn to every time it dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos, deems it advisable.Le prélèvement imposç.par le présent règle- Assessments under this by-law are payable ment est payables mensuellement par l'employeur every month by professional employers, artisans professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en and employees without notice, demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou Should a professional employer or an artisan d'un artisan de payer ou de donner les renseigne- refuse to pay or to give the necessary information, ments nédessaires, un avis de cinq (5) jours lui he will be given five (5) days' notice to fulfil his sera donné pour remplir ses obligations envers le obligations towards the Parity Committee.Comité paritaire.3.Rapport financier 3.Financial report D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes siuvantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of his financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31. 2112 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1958, Tome 85, N° 26 Ci-annexé, un état (les recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de détail de la Fourrure de Montréal et du district, pour la période comprise entre le 8 juin 1953 et le 31 mars 1954.Le Comité paritaire du Commerce de Détail de la Fourrure de Montréal et du District État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 8 juin 1953 et le 31 mars 1954.Recettes: Cotisations (]A de 1%): Employeurs professionnels.84,500.00 Salariés.4,500.00 Artisans.\u2022.560.00 89,560.00 Déboursés: Inspection, salaire et frais de déplacement.84,810.00 Secrétaire.500.00 Bureau, éclairage, téléphone.750.00 Dépenses d'assemblées, timbres, papeterie, etc.3,000.00 Vérification.200.00 Frais légaux.300.00 S9.560.00 Le Sous-ministre du Travail, ¦ GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité conjoint de l'Industrie de la confection pour dames, dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 2375, du 9 septembre 1937, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 739, du 18 juin 1953 (section \"C\"), le tout d'abord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondu» de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet, 1953, au 30 juin 1954, ladite cotisation s'exerce de la façon suivante: a) Tous les employeurs professionnels de l'industrie de la confection pour dames assujettis au décret numéro 2375 et amendements, doivent verser au Comité conjoint de la confection pour dames, dans la province de Québec une somme équivalente à % de 1% des salaires, bonis et allocations payés à leurs salariés des deux sexes (à l'exception des gérants, surintendant, contremaîtres et employés de bureau) assujettis audit décret.b) Tous les salariés des deux sexes de l'industrie de la confection pour dames, assujettis au décret numéro 2375 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ]/2 de 1% de leur salaire, bonis et allocations, à l'exception des gérants, surintendants, contremaîtres et employés de bureau.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Retail Fur Trade Joint Committee of Montreal and District for the period between June 8, 1953 and March 31, 1954.Retail Fur Trade Joint Committee of Montreal and District Estimate of receipts and disbursements for the period between June 8, 1953 and March 31, 1954.Receipts: Assessments (j^ of 1%): Professional employers.84,500.00 Employees.4,500.00 Artisans.560.00 $9,560.00 Disbursements: Inspection, salary and travelling expenses.$4,810.00 Secretary.500.00 Office, lighting, telephone, etc.750.00 Meeting expenses, postage, stationery, etc.3,000.00 Audition.200.00 Legal fees.300.00 89,560.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 27, 1953.35096-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of the Ladies Cloak and Suit Industry for the Province of Quebec, established under decree number 2375 of September 9, 1937, and amendments, has been authorized by a by-law approval by Order in Council number 739 of June 18, 1953, part \"C\", to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned: 1.Levy The period of levy shall extend from July 1st, 1953, to June 30th, 1954, and apply as hereinafter mentioned : a) All professional employers in the Ladies' Cloak and Suit Industry subject to decree number 2375 and amendments must pay to the Joint Committee of the Ladies' Cloak and Suit Industry, a sum equivalent to 3^ of 1% of salaries, bonuses and allowances paid to their employees of both sexes, with the exception of managers, superintendents, foreman and office employees, subject to the said decree.b) All employees of both sexes of the Ladies' Cloak and Suit Industry, subject to decree number 2375 and amendments are obliged to contribute to the said Parity Committee, a sum equivalent to ]/2 of 1% of their salaries, bonuses and allowances, with the exception of managers, superintendetns, foreman and office employees. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2113 2.Mode de perception L'employeur professionnel doit faire des rapports mensuels, on duplicata, sur des formules fournies par le comité paritaire.Ces rapports doivent indiquer les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, la qualification de tel salarié, les heures régulières et supplémentaires effectuées chaque jour, la nature de tel travail ainsi que les salaires payés, avec mention du mode et de la période de paye.Ces rapports mensuels doivent être signés par l'employeur ou un agent dûment autorisé dont l'original où apparaît la liste de paye doit être adressé aux bureaux du comité paritaire au plus tard le dix du mois suivant.Les employeurs professionnels doivent percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de leurs salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et faire parvenir les montants ainsi perçus audit Comité paritaire en même temps que leur propre cotisation, d.ms les quatre jours qui suivent la date à laquelle les dits salaires hebdomadaires sont payables aux salariés.3.Rapport financier Conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail aux dates fixes suivantes: 31 mars ,30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé un état des recettes et déboursés probables du Comité paritaire pour la période commençant le 1er juillet 1953, et se terminant le 30 juin 1954.Comité conjoint de l'Industrie de la Confection pour Dames dans la province de Québec .État des recettes et déboursés pour une année, du 1er juillet 1953, au 30 juin 1954.Hcccttcs* Cotisations {Y2 de 1%); Employeurs professionnels.$31,000.00 Salariés.31,000.00 Intérêt sur obligations.1,100.00 Revenus légaux.200.00 $63,300.00 Déboursés: Salaires (bureau).$13,500.00 Salaires des inspecteurs et inspections supplémentaires.14,000.00 Administration.10,080.00 837,580.00 Téléphone et télégrammes.520.00 Frais de déplacement.3,400.00 Loyer.3,504.00 Taxes.350.00 Papeterie, timbres et dépenses de bureau.4,350.00 Frais légaux.7,000.00 Audition.600.00 Electricité.30.00 Billet de tramways et déplacement local.250.00 Accessoi res de bu reau.1,000.00 Assurance chômage.250.00 Frais de cautionnement, Dépenses diverses, Enquêtes spéciales, 2.Mode of collection The professional employer must make monthly payroll repots, in duplicate, the form of which to be supplied by the Parity Committee.Theese reports are to indicate the surnames, Christian names and residence of each employee in his employ, the competency of such employee, the regular and extra hours of daily labour, and its nature, as well as the wages paid for such labour, with mention of the method and time of payment Said monthly payroll reports are to be signed by the employer or a duly authorized agent, the original of which, containing the payroll reports, shall be sent to the offices of the Parity Committee not later than the tenth of the month following.The professional employer must collect at the end of each week from the wages of every one of his employees the sums owed to the Parity Committee and remit the amount so collected to the said Parity Committee together with his own assessemnt not later than four (4) days from the date when the said weekly wages were due to the employees.3.Financial Report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.An estimated statement of the receipts and expenditures of the Parity Committee for the period beginning July 1st, 1953, and ending June 30th, 1954, is hereto annexed.The Joint Vommittee of the Ladies' Cloak and Suit Industry of the Province of Quebec Estimates Receipts and Ecpenditures from July 1st, 1953, to June 30th, 1954.Receipts: Assessments (Y of 1 %) : Professional Employers.$31,000.00 Employees.31,000.00 Bond Interest.1,100.00 Miscellaneous Legal Income.200.00 $63,300.00 Expenditures: Office Salaries.$13,500.00 Inspectors' Salaries and extra Inspection .14,000.00 Administration.10,080.00 837,580.00 Telephone & Telegraph.520.00 Travel ling Expenses.3,400.00 Rent.3,504.00 Taxes.350.00 Stationery, Postage, and Office Expense.4,350.00 Legal Fees.7,000.00 Audit Fees .600.00 Lights.30.00 Carfare & Local Transportation .250.00 Office Equipment.1,000.00 Unemployment Insurance.250.00 Insurance Guarantee Bond, Miscellaneous Expenses Special Investigations 2114 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 Frais:de banque, Jetons de présence, Dépenses des inspecteurs, etc.4,200.00 $25,454.00 $03,034.00 Surplus prévu.266.00 $63,300.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministre du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), qu'il a l'intention de recommander l'approbation des modifications suivantes au décret numéro 2861 du 17 juillet 1946 et amendements, relatif aux établissements commerciaux dans la ville de Richmond, la municipalité de Melbourne et le territoire compris dans un rayon de trois (3) milles de leurs limites.1° Remplacer le paragraphe \"c-ii\" de l'article IV par le suivant: \"c-ii) jusqu'à 6.00 p.m.le mercredi, lorsqu'il y aura un jour de fête chômé pendant la semaine.\" 2° Au paragraphe \"c'iii\" de l'article IV, la phrase suivante sera ajoutée: \"Toutefois, le travail doit cesser à 6.00 p.m.la veille de Noël.\" 3° Le paragraphe \"b\" de l'article V sera remplacé par le suivant: \"b) Dans le cas où la St-Jean Baptiste (24 juin) ou le jour de la Confédération (1er juillet) tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant sera chômé.Dans le cas du 24 mai, il sera chômé le jour de la proclamation faite par le gouvernement fédéral.\" 4° A l'article VII, les mots \"du beurre et du fromage\" seront ajoutés.- 5° Le premier paragraphe de l'article XVI sera remplacé par le suivant: \"XVI.Salaires minima: Les taux de salaires pour les salariés des deux sexes ne doivent pas être inférieurs à ceux ci-après mentionnés: 80% Classe \"A\".825.00 20% Classe \"B\".20.00\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o Bank Charges Committee Meeting Expenses Inspectors' Expenses, Etc.4,200.00 $25,454.00 $63,034.00 Estimated Surplus.266.00 $63.300.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 27, 1953.35096-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that he intends to recommend the approval of the following amendments to the decree No.2861 of July 17, 1946, as amended, relating to the commercial establishments in the town of Richmond, the Municipality of Melbourne and the territory comprised in a radius of three (3) miles from their limits: 1.Subsection \"c-ii\" of section IV will be replaced by the following: \"c-ii) until 6.00 p.m.Wednesday, when a holiday falls in the week.\" 2.In subsection \"c-iii\" of section IV, the following sentence will be added: \"However, work shall cease at 6.00 p.m.on Christmas eve.\" 3.Subsection \"b\" of section V will bo replaced by the following: \"b) Whenever St.John the Baptiste Day (June 24) or Confederation Day (July 1st) fall on a Saturday or Sunday, the following Monday is not worked.As for May 24, it shall be observed on the date set by proclamation issued by the Federal Government.\" 4.In section VII, the words \"butter and cheese\" will be added.5.The first paragraph of section XVI will be replaced by the following: \"XVI.Minimum wages: Rates of wages for male and female employees shall not be less than the following: 80% Classe \"A\".825.00 20% Class \"B\".20.00\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Ga'ette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 27, 1953.35096-o AVIS DE MODLFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du camionnage dans l'île de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 913 du 16 juin 1948, lui ont présenté une requête à l'effet NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the trucking industry in the Island of Montreal, rendered obligatory by Decree number 913 of June 16, 1948 and amendments, have submitted to him a re- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, 9une 27th, 1953, Vol.85, No.26 2115 d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° Les articles I et II seront remplacés par les suivants: \"I.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale comprend la cité de Montréal et les villes ou municipalités situées sur l'île de Montréal, y compris et sans restriction la cité de Lachine mais à l'est seulement de la cité de Lachine.\" \"H.a) Juridiction industrielle: Sont assujettis aux dispositions du décret: les employeurs professionnels et artisans qui sont munis d'un permis de la Régie des Transports en vertu du chapitre 143 des Statuts réfondus de Quebec, 1941 et ses amendements» ou qui font du transport par camion pour autrui moyennant rémunération et sans permis de ladite Régie.Sont aussi assujettis les employeurs locataires de camions de location, que ce soit pour leur propre service ou celui des tiers, et qui ont leur place d'affaires ou d'activités dans la cité de Montréal ou le territoire sous la juridiction territoriale du présent décret.Le présent décret ne régit pas cependant le transport du lieu de l'exécution du contrat au lieu de décharge, des déblais ou de la pierre d'excavation et des matériaux enlevés ou démolis.Le décret ne s'applique pas aux camionneurs publics et à leurs salariés faisant le transport sur une route régulière entre la cité de Montréal et tout endroit situé en dehors de l'île de Montréal.Le décret ne s'applique pas aux opérations complétant le transport à longue distance, telles opérations comprenant la cueillette et la livraison des marchandises.Le présent décret ne s'applique pas non plus aux \"Drive Yourself\" utilisant des camions de moins d'une tonne.6) Juridiction professionnelle: Le présent décret s'applique aux chauffeurs de camions, aides-chauffeurs, artisans, pointeurs, manutenteurs de fret, hommes d'entrepôt et chauffeurs de camions de location, mais ne s'applique pas aux contremaîtres, aux employés de bureau, aux employés cléricaux et aux employés qui ont pouvoir d'embaucher et de congédier.\" 2° L'article VIII sera remplacé par le suivant: \"VLTI.Dispositions particulières s'àppliquant aux salariés qui portent des armes à feu: 1.Salaires: a) Tout salarié portant une arme à feu et faisant le transport des monnaies, titres et valeurs doit recevoir les taux de salaires suivants: ' Vheure Assistant caissier.$1.60 Messagers.'.1.50 Chauffeurs et payeurs (tellers).1.40 Garde.: 1.30 b) Tout salarié désigné à une classification plus élevée doit recevoir le taux horaire régulier établi pour telle classification pour tout le temps consacré à cette classification plus élevée.Cependant, on ne doit pas réduire le taux horaire d'un salarié affecté à une classification inférieure.2.Heures de travail: a) L'échelle de salaires ci-haut mentionnée s'applique aux premières quarante-quatre (44) heures de travail de la semaine.Tout travail effectué en plus de ces 44 heures dans une semaine doit être rémunéré à raison de salaire et demi par rapport aux taux réguliers apparaissant ci-haut.b) On doit garantir à tout salarié régidier et permanent quarante-quatre (44) heures de tra- quest to amend the said decree, as already amended, in the following manner: 1.Sections I and II will be replaced by the following: \"I.Territorial Jurisdiction: The territorial jurisdiction includes the City of Montreal and anyone of the cities, towns or municipalities situated on the Island of Montreal, including and without restriction the city of Lachine, but East of the City of Lachine only.\" \"II.a) Industrial Jxiridiction: Are subject to the provisions of this decree: all professional employers and artisans who hold a permit from the Transportation Board under chapter 143 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, as amended or who are engaged in the trucking business for payment without a permit of the said Board.Are also subject a'l employers who lease a drive-yourself truck, for their own use or that of a third party, and all those who have their office or place of business in the City of Montreal or in the territory under the territorial jurisdiction of this decree.The present decree does not apply to the transport from the job to the dumping ground, of excavated material or stone and of demolished or cleared material.The decree does not apply to those public truckers and their employees engaged in driving over a regular route between the city of Montreal and any point outside the Island of Montreal.It does not extend to delivery or pick-up operations for the completion of highway transportation.The present decree does not apply to \"Drive Yourself\" concerns using trucks under one ton.b) Professional Jurisdiction: The present decree applies to truck drivers (chauffeurs), helpers to chauffeurs, artisans, dockmen, checkers, warehousemen and truck drivers on leased trucks (drive-yourself) but shall not include foremen, office and clerical employees, or employees who have the power to hire or discharge.\" 2° Section VIII will be replaced by the following : VIII.Provisions applying to employees carrying fire arms: 1.Wages: a) Employees carrying firearms or engaged in the transportation of monies, securities and valuables shall receive the following hourly rates of pay: per hour Assistant Cashiers.$1.60 Messengers.1.50 Chauffeurs and Tellers.1.40 Guards.1.30 b) Any employee assigned to work in a higher classification shall receive the straight time hourly rates applying to the higher classification for all hours actually worked in such higher classification and no employee shall suffer any reduction in his straight time hourly rate by reason of his being assigned to work in a lower classification.2.Hours of work: a) The above scale of wages shall apply to the first forty-four (44) hours of work in any week.All hours of work in excess of forty-four (44) hours in any one week shall be paid for at one and one-half times (1^) the regular rates listed hereinbefore.6) All regular, full time employees shall be guaranteed forty-four (44) hours of work per 2116 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 20 vail par semaine ou l'équivalent en rémunération.L'employeur ne peut être tenu de garder un salarié au travail en plus du nombre d'heures garanti par semaine.c) On doit garantir à tout salarié requis de travailler le dimanche un minimum de quatre (4) heures de travail ou l'équivalent en rémunération au taux de salaire et demi basé sur le salaire régulier pour sa classification; la durée de tel travail ne doit pas être ajoutée aux heures régulières hebdomadaires.d) Pour tout appel au travail, un salarié a droit à un minimum de quatre (4) heures de travail ou à une rémunération équivalente.e) La garantie minimum pour chaque appel au travail s'applique également lorsqu'un salarié régulier et permanent est appelé pour une période incomplète de travail.3.Jours de fête: a) Pour les fins du présent article, les jours suivants doivent être considérés comme jours de fête: le Premier de l'An, le Vendredi Saint, le Jour de la Confédération, le Jour d'Actions de Grâce et le Jour de Noël.b) Tout salarié régulier et permanent qui a travaillé un minimum de trois (3) jours pendant la semaine où tombe l'un des jours mentionnés plus haut doit recevoir un crédit de sept heures et trois-dixièmes (7.3) pour tel jour de fête et ces heures doivent être considérées comme heures de travail et ajoutées aux autres heures de travail de la semaine.c) Tout salarié requis de travailler l'un des jours de fête énumérés ci-haut doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport aux taux réguliers mentionnés dans le présent article pour toute heure de travail ainsi effectuée, et telles heures ne doivent pas être ajoutées aux heures régulières de travail de la semaine.Les salariés qui font un tel travail doivent être rémunérés au taux de salaire et demi par rapport au taux régulier établi pour la classification à laquelle ils appartiennent ce jour-là.d) Tout salarié non régulier qui travaille quatre (4) jours ou plus durant une semaine où tombe l'un des jours de fête énumérés ci-haut doit recevoir un crédit et une rémunération de sept heures et trois-dixièmes (7.3) pour tel jour de fête au taux établi pour la classification à laquelle appartient ce salarié.Ces heures ne doivent pas être considérées comme heures de travail ou ajoutées aux autres heures de travail de la semaine.4.Vacances: a) Tout salarié régulier et permanent qui a travaillé toute l'année de calendrier précédente, du 1er avril au 31 mars, à titre de salarié régulier et permanent, a droit à un congé d'une (1) semaine; un salarié qui a travaillé les deux années complètes précédentes de calendrier, à titre de salarié régulier et permanent a droit à un congé de deux (2) semaines.b) La rémunération de vacances de tels salariés doit être calculée sur la base de quarante-quatre (44) heures au taux horaire régulier pour chaque semaine de vacances.c) Si un jour de fête tombe pendant la période de vacances d'un salarié régulier et permanent, il a alors droit à une journée supplémentaire de vacances ou à rémunération pour telle journée calculée sur la base de sept heures et trois-dixièmes (7.3) au taux horaire régulier.d) La période de vacances de chaque année s'étend du 1er avril au 30 septembre; les vacances doivent être prises durant cette période à moins d'entente à ce contraire entre l'employeur et le salarié.e) Les droits d'ancienneté sont reconnus chez les salariés des classifications de messagers, week or the equivalent thereof in pay.The employer shall not be obligated to work employees in excess of the number of hours guaranteed per week.c) Any employee required to work on Sunday shall be guaranteed a minimum of four (4) hours of work or the equivalent thereof in pay at one and one-half times (IK) the basic hourly rate applicable to his classification and such hours shall not be added in the regular weekly hours of work.d) All employees called for work shall receive a minimum of four (4) hours of work or the equivalent thereof in pay.e) No regular full time employee shall be required to work a split shift without being compensated for the minimum guarantee on each call.3.Holidays: a) The following days shall be designated as holidays under the terms of this section: New Year's Day, Good Friday, Confederation Day, Labour Day, Thanksgiving Day and Christmas.b) All regular, full time employees who work three (3) or more days during a week in which one of the above designated holiday occurs, shall be credited with seven and three-tenths (7.3) hours for such holiday and such hours shall be considered as hours worked and be added in the accumulated hours of work for that week.c) All employees required to work on any of the holidays enumerated above shall be paid one and one-half times (1^) the regular rate~ listed hereinbefore for all hours actually worked, and such hours of work shall Qot be added in the regular weekly hours of work.Employees assigned to such work shall be paid one and one-half times (1^) the hourly rate prevailing for the respective classification to which they are assigned on such work.d) All part-time employees working four (4) or more days during a week in which one of the above designated holidays occurs, shall be credited with and paid for seven and three-tenths (7.3) hours for each such holiday at the wage rate applicable to such employee's respective classification.Such hours shall not be considered hours of work and shall not be added in the accumulated hours of work for that week.4.Vacations: a) All regular full time employees who have worked the full previous calender year, April 1 to March 31, as regular full time employees, shall be given a vacation of one (1) week, and such employees who have worked the last two (2) full calendar years, as regular full time employees, shall be given a vacation of two (2) weeks.b) Vacation pay for such employees shall be computed on the basis of forty-four (44) hours at straight time hourly rates for each week of vacation.c) If a designated holiday occurs during a regular full time employee's paid vacation period, he shall be granted one additional day's vacation or pay in lieu thereof computed on the basis of seven and three-tenths (7.3) hours at straight time hourly rates.d) The vacation period in each year shall run from April 1 to September 30, and vacations must be taken during the vacation period except when otherwise mutually agreed upon between the employer and the employee.e) Seniority shall prevail among employees in the respective classifications of Messenger, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2117 chauffeurs et gardes dans le choix de la période de vacances à condition, toutefois, que l'employeur puisse déterminer le nombre maximum des salariés de chaque classification qui pourront s'absenter à la fois pour vacances./) La rémunération pour vacances de tout salarié qui a moins d'une année de service continu pour l'employeur, ou qui quitte le service de l'employeur, doit être déterminée selon les dispositions de l'ordonnance X° 3, revisée, à condition toutefois, sujet à l'approbation du Ministre du Travail, que la rémunération pour vacances soit calculée sur la rémunération du salarié pendant l'année précédente s'étendant du 1er avril au 31 mars.g) Tout salarié non régulier qui a complété deux (2) années de service continu pour l'employeur a»i 31 mars de toute année et qui, en moyenne, a travaillé quarante-deux (42) heures par semaine pendant une période d'une (1) année se terminant le 31 mars a droit à un congé payé de deux (2) semaines pendant la prochaine période de vacances.La rémunération pour vacances de tel salarié non régulier doit être calculée sur la base de quatre pourcent (4%) du salaire payé à tel employé, y compris toute rémunération pour congé payé pendant la période d'une année se terminant le ou avant le 31 mars avec la fin de la dernière période de paye complète hebdomadaire.Cependant, la rémunération pour vacances de tout salarié non régulier ne doit pas être supérieure à la rémunération pour quatre-vingt-huit (88) heures de travail au taux régulier de salaire établi pour la classification de tel salarié.5.Assurance-groupe: L'employeur consent à prendre une ou des polices d'assurance-groupe non contributoires, et à en payer les primes, pour le bénéfice de ses salariés réguliers et permanents régis par le présent article et de leurs dépendants éligibles; la sorte de police et le montant seront déterminés après entente entre les parties concernées.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o AVIS L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q;, 1941, chapitre 163 et amendements), que \"Sherbrooke Paper Products Limited\" lui a présenté une requête à l'effet d'être acceptée comme partie co-contractante à la convention collective de travail relative à l'industrie de la boite de carton gaufré, rendue obligatoire par le décret numéro 561 du 11 mars 1942 et amendements.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o Chauffeurs and Guards as to picking vacation time, provided however, that the employer shall determine the maximum number of employees in each classification who shall be absent due to vacation during any one period./) Vacation pay for any employee who has less than one year's continuous service with the employer, or who leaves the employ of the employer, shall be granted in accord with Ordinance No.3 revised, provided that, subject to approval of the Minister of Labour, vacation pay shall be based on the employee's earnings during the calendar years April 1 to March 31.g) All part-time employees who have completed two (2) years of continuous employment with the employer on March 31, of any year, and who have averaged forty-two (42) hours of work per week for a period of one (1) year ending on said March 31, shall be givenavaca-tion of two (2) weeks with pay during the ensuing vacation period.The vacation, pay for such part-time employees shall be computed on the basis of four per cent (4%) of the wages paid to said employees, including any vacation pay during the one-year period ending with the close of the last full weekly pay period on or before March 31, provided however, that the vocation pay for any part time employee shall not exceed an amount equal to pay for eighty-eight (88) hours of work at the straight time wage rate applicable to that respectife employee's classification.5.Groupe Insurance: The employer agrees to take out, maintain and pay the premium on a Non-Contributory Group Insurance policy or policies, providing insurance benefits for tis regular full time employees, hereby covered, and their eligible dependents, of the type and in the amounts as determined by the parties concerned herewith.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested-parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, .Quebec, June 27, 1953.35096-o NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that \"Sherbrooke Paper Products Limited\" has submitted to him a request to be accepted as co-contracting party to the collective labour agreement relating to the corrugated paper box industry, rendered obligatory by decree No.561 of March 11, 1942 and amendments.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 27, 1953.35096-o 2118 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 86, N° 26 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), qu'une requête lui a été présentée à l'effet de modifier le décret numéro 891 du 28 août 1952, relatif à l'industrie'de la peinture dans la province de la façon suivante: 1° Le paragraphe \"k\" de l'article III sera radié.2° Le paragraphe 9.intitulé \"Huile de lin\", de l'article IV, sera radié.3° Les mots \"de l'huile de lin et d'autres huiles\" seront radiés du paragraphe \"c\" de l'article 4° L'article XII sera radié.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1953.35096-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that a petition has been submitted to him to amend the decree No.891 of August 28, 1952, relating to the paint industry in the province, as follows: 1.Subsection \"/,\u2022\" of section III will be deleted.2.Subsection 9, entitled \"Linseed oil Mill\", of section IV, will be deleted.3.The words \"linseed and other oil manufacturing\" will be deleted from subsection \"c\" of section VI.4.Section XII will be stricken off.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 27, 1953.35096-o Action en séparation de biens Province de Québec, district d'Iberville, Cour supérieure, N° 7548.Dame Thérèse Viens, demanderesse; vs Rosario Théberge, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée le 10 juin 1953 en cette cause.Saint-Jean, P.Q., le 18 juin 1953.Le Procureur de la demanderesse, 35090-o MAURICE J.DEMERS.Action for separation as to property Province of Quebec, district of Iberville, Supe rior Court, No.7548.Dame Thérèse Viens plaintiff; vs Rosario Théberge, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case, on June 10, 1953.Saint-Jean, P.Q., June 18, 1953.MAURICE J.DEMERS, 35090 Attorney for Plaintiff.Avis divers AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Grace Gospel Chapel\", une des Églises de la \"Christian Brethen\" de la province de Quebec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la p/ovince de Québec, pour obtenir son incorporation, en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus de la province de Québec, 1941 et amendements.Montréal, 30 mai 1953.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMLESON.231 ouest, rue St-Jacques, Montréal.34968-23-4 AVIS Avis est donné par les présents qu'un règlement spécial a été décrété par les directeurs de \"Prupos Flooring Inc.\" le 15ème jour de juin 1953 en vertu de la loi des Compagnies de Québec, pourvoyant a la distribution de l'actif de la Compagnie parmi ses actionnaires.Montréal, le 19ème jour de juin, 1953.Le Vice-président et Secrétaire, 35086-o (signé) MAX PRUPAS, Miscellaneous Notices PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Grace Gospel Chapel\", one of the Christian Brethren Churches in the Province of Quebec, will present a Petition to the Lieut.-Governbr-in-Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941 and Amendments.\u2022 Montreal, May 30th, 1953.CERINI & JAM3ESON, Solicitors for Petitioner.231 St.James St.West, Montréal.34968-23-4-o NOTICE Notice is hereby given that a special By-Law was enacted by the Directors of \"Prupas Flooring Inc.\" on June 15th, 1953, under the Provisions of the Quebec Companies' Act, providing for the distribution of the assets of the Company amongst its shareholders.Montreal, June 19th, 1953.(sgd) MAX PRUPAS, 35086-O Vice-President and Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2119 AVIS NOTICE (Loi des syndicats professionnels) (Professional Syndicate;.' Act) La formation d'une société, sous le nom de The formation of an association under the \"Association des Employés de United Paper name of \"Association des Employés de United Box \u2014 United Paper Box Employees Associa- Paper Box \u2014 United Paper Box Employees tion\", pour l'étude, la défense et le développe- Association\", for the study, defence and promoment des intérêts économiques, sociaux et mo- tion of the economic, social and moral interests raux de ses membres, a été autorisée par le of its members, has been authorized by the Secrétaire de la Province, le trente mai 1953.Provincial Secretary on May thirtieth, 1953.Le siège social du syndicat professionnel pré- The principal place of business of the said cité est situé à Montréal, dans le district judi- professional syndicate is at Montreal, in the ciaire de Montréal.judicial district of Montreal.Le Sous-secrétaire adjoint LUCIEN DARVEAU, de la Province, Acting Under Secretary 35082-o LUCIEN DARVEAU.35082 of the Province.(P.G.8275-53) Bel Air Clothing Inc.Vêtements Bel Air Inc.Sur proposition, il est unanimement résolu que soit adopté le règlement N° 4 de la compagnie ('¦dictant que le nombre des directeurs est porté de trois (3) à quatre (4).Vraie copie certifiée du règlement N° 4 de \"Bel Air Clothing Inc.\u2014 Vêtements Bel Air Inc.\", adopté par les directeurs de cette compagnie, à une assemblée tenue le 27 mai 1953 et ratifié par tous les actionnaires de la compagnie à une assemblée subséquente tenue à cette même date.Le Secrétaire, 35083-o JEAN-M.ROBERGE.(A.G.8275-53) Bel Air Clothing Inc.Vêtements Bel Air Inc.Upon recommendation, it is unanimously resolved that, company's by-law No.4 decreeing that the number of directors be increased from three (3) to four (4), be adopted.Certified true copy of by-law No.4 of \"Bel Air Clothing Inc.\u2014 Vêtements Bel Air Inc.\", adopted by the directors of said company, at a meeting held May 27, 1953, and ratified by all the shareholders of the company at a subsequent meeting held on the same date.JEAN M.ROBERGE, 35083 Secretary.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Chute aux Outardes\", en date du 17 mai 1953, dont le siège social est situé à Chûte-aux-Outardes, dans le comté de Saguenay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province., Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 4 juin 1953.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 35084-o LUCIEN DARVEAU.(P.G.13394-53) Premier Property Limited Sur motion dûment proposée et secondée il a été résolu à l'unanimité: que l'article 1 du règlement 3, de manière à pourvoir à une augmentation du nombre des directeurs de trois à cinq, soit et il est par les présentes amendé pour se lire comme suit: \"Le bureau de direction sera formé de cinq directeurs.\" Certifié vraie copie de l'amendement de l'article 1 du règlement 3 de \"Premier Property Limited\" adopté à une assemblée des directeurs dûment convoquée et tenue le 30e jour d'avril 1953 et subséquemment confirmé le même jour par les votes de plus des deux tiers des actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale spéciale des actionnaires dûment convoqués à cette fin.(Sceau) Le Président, J.B.PENNEFATHER.Le Secrétaire, 35085 K.J.DOIG.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Chute aux Outardes\", under date May 17, 1953, whereof the head office is at Chûte-aux-Outardes, in the county of Saguenay, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary June 4, 1953.LUCIEN DARVEAU, Acting Under Secretary 35084 of the Province.(P.G.13394-53) Premier Property Limited Upon motion duly proposed and seconded it was unanimously resolved that article 1 of By-law 3 so as to provide for an increase in the number of directors from three to five, be and it is hereby amended to read as follows: \"The Board of Directors shall consist of five Directors.\" Certified to be a true copy of the amendment to Article 1 of By-law 3 of Premier Property Limited adopted at a meeting of the Directors duly called and held on the 30th day of April 1953 and subsequently on the same day confirmed by the votes of more than two thirds of the shareholders present or represented at a Special General Meeting of the shareholders duly called for the purpose.(Seal) J.B.PENNEFATHER, President.K.J.DOIG, 35085-o Secretary. 2120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 Village de St-Alexis-de-la-Grande-Baie (Comté de Chicoutimi) Avis public est par les présentes donné que la Commission municipale de Québec, à sa séance en date du 18 juin 1953, a adopté la résolution suivante: \"Il est résolu que, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, c.207), la corporation du village de Saint-AIexis-de-Ia-Grande-Baie, dans le comté de Chicoutimi, ne soit plus, à compter du 6 juillet 1953, considérée comme étant en défaut au sens de la section V de ladite loi.\" Québec, le 19 juin 1953.La Commission municipale de Québec, Le Secrétaire, 35087-o MAURICE R.MARCOTTE.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif du Tracteur de Girardville\", en date du 1er mai 1953, dont le siège social est situé à Girardville, dans le comté de Roberval, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 4 juin 1953.\u2022 Le Sous-secrétaire adjoint de la province, 35091-o LUCIEN DARVEAU.(P.G.1497-53) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le 19 juin 1953, les règlements comprenant les articles I à VII inclusivement de 1'\" Associât ion des Taver-niers de la cité de Grand'Mère et du district Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 20 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35092-o JEAN BRUCHÉSI.Village of St.Alexis de la Grande baie (County of Chicoutimi) Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission has adopted the following resolution at its sitting of June 18, 1953: \"Resolved that in accordance with the provisions of Section 52 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, C.207), from and after July 6, 1953, the Corporation of the Village of St.Alexis de la Grande Baie, in the County of Chicoutimi, shall no longer be considered in default within the meaning of Division V of the said act.\" Quebec, June 19, 1953.The Quebec Municipal Commission, MAURICE R.MARCOTTE, 35087-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif du Tracteur de Girardville\" under date May 1st, 1953, whereof the head office is at Girardville, in- the county of Roberval, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretarv, June 4, 1953.LUCIEN DARVEAU, 35091 Acting Under Secretary of the Province.(A.G.1497-53) Notice is hereby given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the 'Provincial Secretary, on June 19th, 1953, approved by-laws including articles I to VII inclusive of the \"Association des Taveruiers de la cité de Grand'Mère et du district Inc.\", and such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, June 20, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35092 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Killarney Credit Union\", en date du 11 juin 1953, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 16 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35097-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment ïreçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse d'Établissement Rural de Joliette\", en date du 15 mai 1953, dont le siège social est situé à Joliette, dans le comté de Joliette, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 12 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la province, 35099-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Killarney Credit Union\" under date the 11th day of June 1953, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 16th day of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35097 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse d'Établissement Rural de Joliette\", under date the 15th day of May, 1953, whereof the head office is at Joliette, in the county of Joliette and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial, this 12th dav of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35099 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2121 Albert Nagley Ltd.Règlement No 17 Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires et n'a pas de dettes, responsabilités ou obligations qui n'ont pas été payées ou pourvues; Qu'il soit résolu: Que l'actif de la compagnie soit distribué au pro rata entre les actionnaires.Montréal, 17 juin 1953.Albert Nagley Ltd.Par le Procureur de la compagnie, 35098 N.L.RAPPAPORT.AVIS , (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Henri de Taillon\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-deux mai 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Heiiri-de-Taillon, dans le comté de Lac St-Jean.Le Sous-secrétaire adjoint de la Province, 35100-o LUCIEN DARVEAU.Avis est donné que, par l'arrêté en Conseil daté du 18 juin 1953, la compagnie \"The Travelers Indemnity Company\" a été autorisée à se porter caution en justice dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de garanties, S.R.Q.1941, chapitre 285.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 25ième jour de juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35079 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats coopératifs de Québec) Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation d'une fédération de syndicats coopératifs dont le nom est \"L'Idéale Fédérée; Centrale de Consommation\", en date du 19 mai 1953, dont le siège social est situé à Cap-aux-Meules, dans le comté des Iles-de-la-Madeleine, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 23 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la province, 35110-o JEAN BRUCHÉSI.Chartes \u2014 Abandon de Mor-Lite Realty Corporation AVIS Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Mor-Lite Albert Nagley Ltd.Bij-Iaxw No.17 Whereas the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding-up its affairs and has no debts, liabilities, or obligations that have not been paid or provided for; Be it resolved: That the assets of the Company be distributed ratcably among the Shareholders.Montreal, June 17, 1953.Albert Nagley Ltd.Per N.L.RAPPAPORT, 35098-o Attorney for the Company.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Henri de Taillon\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May twenty-second, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Henri-de-Taillon, in the Countv of Lake St.John.LUCIEN DARVEAU, 35100 Acting-Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that, by Order in Council dated June 18th, 1953, \"The Travelers Indemnity Company\" was authorized to become a judicial surety in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Guarantee Companies Act, R.S.Q.1941, chapter 285.Given at the office of the Provincial Secretary this 25th day of June, 1953.JEAN BRUCHÉSI» 35079-o Under-Secretary of the Province.NOTICE (Quebec Cooperative Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of a federation of cooperative syndicates, the name of which is \"L'Idéal Fédérée, Centrale de Consommation\", under date the nineteenth day of May 1953, whereof the head office is at Cap-aux-Meules, in the county of Magdelan Islands and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this June 23, 1953.' JEAN BRUCHÉSI, 35110 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of .Mor-Lite Realty Corporation NOTICE Undei the.provisions of the Quebec Companies' Act, Mor-Lite Realty Corporation hereby 2122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 Realty Corporation\" donne, par les présentes, avis qu'elle demandera la permission d'abandonner sa charte et la fixation d'une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Montréal, 19 juin 1953.Le Secrétaire, 35088 (Signé) L.LIGHT.Franklin Fruit Growers Co.Avis est, par les présentes, donné qu'une demande sera faite auprès du Procureur général, pour obtenir l'annullation, sur consentement des actionnaires, de la charte de la corporation susdite.Franklin Centre, le 17 juin 1953.Le Secrétaire, 35093-o ÉMILIEN FAILLE.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Albert Nagley Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, en date du 15 juin 1945, sous le nom de Leymar Ltd, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 17 juin 1953.Le Procureur de Albert Nagley Ltd., 35098 N.L.RAPPAPORT.gives notice that it will make application for the acceptance of the surrender of its charter, and to fix a date upon and from which the company shall be dissolved.Montreal, June 19th, 1953.(Signed) L.LIGHT, 35088-o Secretary.Franklin Fruit Growers Co.Notice is hereby given that an application is to be made to the Attorney General, for the surrender and cancellation, by consent of the shareholders, of the above corporation.Franklin Centre, June 17, 1953.ÉMILIEN FAILLE, 35093-o Secretary.Notice is hereby given that \"Albert Nagley Ltd.,\" incorporated by Letters Patent, of the Province of Quebec, dated June 15, 1945, under the name of Leymar Ltd, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, June 17, 1953.N.L.RAPPAPORT, 35098-o Attorney for Albert Nagley Ltd.Département de l'Instruction publique Department of Education N° 378-53.Québec, le 12 juin 1953.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Grenville N° 3, dans le comté d'Argenteuil, en celui de \"Pointe-aux-Chênes\", même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35059-25-2-o O.J.DESAULNIERS.N°618-53 Québec, le 17 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1953, de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Dorothé N° 2, dans le comté de Laval, les lots Nos 27 et 28 du cadastre officiel de la paroisse de St-Martin, et de les annexer à celle du village de Saint-Martin, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35080-o O.J.DESAULNIERS.N° 888-52 Québec, le 17 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1953, de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Flore, dans le comté de St-Maurice un territoire situé dans la seigneurie du Cap de la Madeleine, comprenant en référence au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Flore, tous les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, ruelles, rivières, îles, cours d'eau ou partie d'iceux,' renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant du point d'intersection de la rive droite ou rive ouest de la rivière St-Maurice avec la ligne separative des lots Nos 38 et 39; de là, passant par les lignes et démarcations suivantes en continuité les unes des autres: en suivant les No.378-53 Quebec, Jjune 12, 1953.Application is made to change the name of the school municipality of Grenville No.3, in the county of Argenteuil, into that of \"Pointe-aux-Chênes\", same county.O.J.DESAULNLERS, 35059-25-2 Superintendent of Education.No.618-53 Quebec, June 17, 1953.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council dated June 11, 1953, to detach from the school municipality of Ste-Dorothée No.2, in the County of Laval, lots Nos.27 and 28 of the official cadastre of the parish of St.Martin, and annex them to that of the village of Saint Martin, same county.This Order in Council will take effect the first day of July 1953.0.J.DESAULND3RS, 35080 Superintendent of Education.No.888-52 Quebec, June 17, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council, dated June 11, 1953, to detach from the school municipality of Ste-Flore, county of St.Maurice, a territory situate in the seigniory of Cap de la Madeleine, comprising, with reference to the official cadastre of the parish of Sainte-Flore, all lots or parts of lots and their present and future subdivisions, as well as roads, streets, lanes, rivers, islands, water courses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: Starting at the intersection point of the right bank or west bank of the St.Maurice River with the division line of lots Nos.38 and 39, thence, passing by the demarcation lines successively: by following the limits of the City of Shawinigan QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2123 limites de la Cité de Shawinigan Falls, ladite ligne separative des lots Nos 38 et 39, traversant la route régionale N° 19, continuant vers le nord-ouest, la ligne separative des lots Nos 46 et 47, laissant les limites de la Cité de Shawinigan Falls continuant vers le nord-est, la ligne séparant le rang Stc-Catherinc N° 2 de la concession du chemin des Piles côté sud-est, jusqu'à la limite de la Cité de Grand'Mère, continuant en suivant ladite limite: la ligne séparant les lots Nos 72 et 73, la ligne séparant le rang Stc-Catherine N° 2 et le rang Ste-Catherine N° 1, la ligne séparant les lots Nos 5 et 6 et son prolongement jusqu'à l'axe de la rivière St-Maurice; laissant les limites de la Cité de Grand'Mère, vers le sud-ouest en suivant l'axe de la rivière St-Maurice jusqu'à un point situé dans le prolongement de la ligne entre les lots Nos 38 et 39 et suivant ledit prolongement jusqu'au point de départ: lequel territoire à être formé en une municipalité scolaire distincte sous le nom de \"Municipalité scolaire du Village de Shawinigan-Est, dans le comté municipal de St-Maurice.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35080-o O.J.DESAULNIERS.N° 87-53.Québec, le 17 juin 1953.Il a plu à Son Honneur le Lieutcnant-gouver-' neur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1953, de détacher de la municipalité scolaire de Shipton, dans le comté de Richmond, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de Danville, dans le même comté.Un territoire comprenant les lots, parties de lot, avec les subdivisions actuelles et futures, chemins, cours d'eau, rues, ruelles, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant du point d'intersection du chemin de fer Asbestos-Danville Railway avec le côté sud-est du chemin situé le long de la ligne separative des lots 16-B et 17-B du rang III (3), de là dans une direction sud-ouest, lediUcôté sud-est dudit - chemin et son prolongement jusqu'à son point d'intersection avec le côté sud du chemin public Asbestos-Danville; de là ledit côté sud du chemin public jusqu'à la ligne separative des lots 15-D et 16-D du rang IV (4); de là dans une direction sud-ouest la ligne separative des lots 15-D et 16-D, son prolongement à travers le lac (Bur-bank's Pond), la ligne sud-est des lots 16-B et 16-A du rang IV (4), la ligne sud-est des lots 16-C et 16-B du rang V (5); de là dans une direction nord-ouest, la ligne separative des lots 16-B et 16-A du rang V (5); de là dans une direction sud-ouest, la ligne sud-est des lots 17-C et 17-A du rang V (5), la ligne sud-est du lot 17-F du rang VI (6); de là dans une direction nord-ouest et dans une direction nord-est, la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 17-F du rang VI (6); de là dans une direction nord-ouest la ligne separative des rangs V et VI (5 et 6) jusqu'à son point d'intersection avec la ligne separative des lots 18-A et 19-A du rang V (5) ; de là dans une direction nord-est ladite ligne separative des lots 18-A et 19-A; de là dans une direction nord-ouest la ligne separative des lots 19-A et 19-B du rang V (5); de là dans une direction nord-est, la ligne nord-ouest des lots 19-B et 19-C du rang V (5); de là dans une direction nord-ouest la ligne separative des rangs IV et V (4 et 5) jusqu'à son point d'intersection avec la ligne separative des lots 24 et 25-A du rang IV (4); de là dans une direction Falls, the said division line of lots Nos.38 and 39 crossing regional road No.19, continuing towards the northwest, the division line of lots Nos.46 and 47, leaving the limits of the City of Shawinigan Falls, continuing towards the northeast, the line dividing range Ste-Catherine No.2 from the concession of the road \"des Piles\", southeast side, to the limit of the City of Grand'Mère, continuing along the said limit: the line dividing lots Nos.72 and 73, the line dividing Range Ste-Catherine No.2 and Range Ste-Catherine No.1, the line separating lots Nos.5 and 6 and its prolongation to the axis of the St-Maurice River: leaving the limits of the City of Grand'Mère, on the southwest by following the axis of the St-Maurice River as far as a point situate in the prolongation of the line between lots Nos.38 and 39 and following the said prolongation to the starting point: which territory to be erected into a separate municipality under the name of \"School Municipality of the Village of Shawini-gan-East, in the municipal county of St.Maurice.* Said Order in Council to take effect on the first day of July, 1953.O.J.DESAULNIERS, 35080 Superintendant of Education.No.87-53.Quebec, June 17, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council, dated June 11, 1953, to detach from the school municipality of Shipton, in the county of Richmond, the following territory to annex it to the school municipality of Danville, in the same county, to wit: A territory comprising lots, parts of lot, with the present and future subdivisions, roads, water courses, streets, lanes, enclosed within the following limits, to wit: Starting from the intersection point of the railroad Asbestos-Danville Railway with the southeast side of the road situate along the division line of lots 16-B and 17-B of range III (3), thence, in a southwesterly direction, the said side southeast of the said road and its prolongation up to its point of intersection with the south side of the Asbestos-Danville road; thence, the said south side of the public road as far as the division line of lots 15-D and 16-D of range IV (4); thence, in a southwesterly direction, the division line of lots 15-D and 16-D, its prolongation across the lake (Burbank's Pond), the southeast line of lots 16-B and 16-A of range IV (4), the southeast line of lots 16-C and 16-B of range V (5); thence, in a northwesterly direction, the division line of lots 16-B and 16-A of range V (5); thence, in a southwesterly direction the southeast line of lots 17-C and 17-A of range V (5), the southeast line of lot 17-F from range VI (6); thence, in a northwesterly direction and in a northeasterly direction, the southwest line and the northwest line of lot 17-F of range VI (6); thence, in a northwesterly direction, the division line of ranges V and VI (5 and 6) as far as its point of intersection with the division line of lots 18-A and 19-A of range V (5); thence, in a northeasterly direction, the said division line of lots 18-A and 19-A; thence, in a northwesterly direction, the division line of lots 19-A and 19:B of range V (5); thence, in a northeasterly direction, the northwest line of lots 19-B and 19-C of range y (5); thence, in a northwesterly direction, the division line of ranges IV and V (4 and 5) as far as the point of intersection with the division line of lots 24 and 25-A of range IV (4); thence, in a northeasterly 2124 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 nord-est ladite ligne separative des lots 24 et 25-A jusqu'à un point situé à mi-chemin entre la ligne separative des rangs III et IV (3 et 4) et celle située entre les rangs IV et V (4 et 5); de là dans une direction sud-est une ligne séparant par la moitié le rang IV (4) et traversant les lots 24, 23-C, 23-A, et limitant avi nord-est les lots 22-A, 21-1) et se prolongeant jusqu'au côté est du chemin public; de là vers le sud le côté est du chemin public jusqu'à la ligne nord du lot 21-J; de là dans une direction est la ligne nord du lot 21-J; de là dans une direction nord-est la ligne separative des lots 20-M et 21-F du rang IV (4); de là dans une direction sud-est la ligne separative des rangs III et IV (3 et 4) jusqu'à son point d'intersection avec le côté est du chemin de fer Asbestos-Danville Railway; de là en suivant le côté est du chemin de fer Asbestos-Danville Railway jusqu'au point de départ.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35080-O O.J.DESAULNIERS.N° 847-50 Québec, le 18 juin 1953.H a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1953, de former du territoire de la Ville de Roxboro, dans le comté de Jacques-Cartier, une municipalité scolaire distincte, pour les contribuables catholiques seulement, qui sera connue et désignée sous le nom de \"La Municiaplité scolaire catholique de Roxboro\", comté de Jacques-Cartier, savoir: Son territoire fait actuellement partie de trois municipalités scolaire, c'est-à-dire: Ste-Gcneviève, N° 3, Côte St-Rémi de Stc-Geneviève N° 4, et Stc-Geneviève, N° 7, dans le comté de Jacques-Cartier.a) Le territoire devant être détaché de la municipalité scolaire de Ste-Geneviève, N° 3, est décrit comme suit, savoir: 1° Les lots originaires Nos 42-48, 49, 311 de la paroisse de Ste-Geneviève; 2° Les lots originaires Nos 43, 44, 45 de la paroisse de Ste-Geneviève (maintenant connus suivant les plans déposés au Ministère des Terres et Forêts, le 5 avril 1945, comme étant les lots Nos 184 à 3*52 inclusivement et partie de 353 du lot originaire 325 de la paroisse de Ste-Geneviève).b) Le territoire devant être détaché de la municipalité scolaire de Côte St-Rémi de Ste-Geneviève, N° 4, est décrit comme suit, savoir: 1° La subdivision N° 1 du lot originaire N° 291 (291-1) de la paroisse de Ste-Geneviève; 2° Le lot originaire N° 292 de la paroisse de Sté-Geneviève à déduire cependant la subdivision N° 44 du lot orignairc 292 de la paroisse de Ste-Geneviève; 3° Le lot originaire N° 293 de la paroisse de Ste-Geneviève, à déduire cependant la subdivision N° 43 du lot originaire N° 293 de la paroisse de Ste-Geneviève.c) Le territoire devant être détaché de la municipalité scolaire de Ste-Geneviève N° 7 et décrit comme suit, savoir: 1° Le lot N° 62 du lot originaire N° 36 (36/62) du cadastre de la paroisse de Ste-Geneviève; 2° La subdivision N° 63 du lot originaire N° 36 du cadastre de la paroisse de Ste-Geneviève, maintenant connu et désigné suivant les plans déposés au Ministère des Terres et Forêts, le 14 novembre 1945, comme étant les subdicisions Nos 1 à 76 inclusivement du N° 63 du lot originaire N°36 (36/63) \u2014 1 à 36 \u2014 63 \u2014 76 inclusivement: direction the said division line of lots 24 and 25-A up to a point situate half-way between the division line of ranges III and IV (3 and 4) and that situate between ranges IV and V (4 and 5) ; thence in a southeasterly direction a line separating by half range IV (4) and crossing lots 24, 23-C, 23-A, and limiting, on the northeast, lots 22-A, 21-D and prolongating itself as far as the eastern side of the public road; thence, towards the south, on the eastern side of the public road -as far as the northern line of lot 21-J; thence, in an easterly direction, the northern line of lot 21-J; thence, in a northeasterly direction, the division line of lots 20-M and 21-F of range IV (4); thence, in a southeasterly direction, the division line of ranges III and IV (3 and 4) as far as its point of intersection with the Eastern side of the railroad Asbestos-Danville Railway, thence, by following the eastern side of the railroad Asbestos-Danville Railway to the starting point.Said Order in Council to take effect on the 1st of July, 1953.O.J.DÉSAULNLERS, 35080 Superintendent of Education.No.847-50 Quebec, June 18, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order inCouncil, dated June 11, 1953, that the territory of the Town of Roxboro, in the county of Jacques-Cartier, be formed into a separate school municipality, for the Catholic taxpayers only, which snail be known and designated under the name of \"The Catholic School Municipality of Roxboro\", county \"of Jacques-Cartier.This territory is presently part of three school municipalities, that is: Ste-Geneviève, No.3, Côté St-Rémi de Ste-Geneviève, No.4, and Ste-Gcneviève, No.7, in the comity of Jacques Car-tier.a) The territory to be detached from the school municipality of Ste-Geneviève, No.3, is described as follows, to wit: 1.Original lots Nos 42 \u2014 48, 49, 311 of the parish of Ste-Geneviève; 2.The original lots Nos.43, 44, 45 of the parish of Ste-Geneviève (now known according to the plans filed with the Department of Lands and Forests, on April 5, 1945, as being lots Nos.184 to 352 inclusively and part of 353 of the original lot 325 of the parish of Ste-Geneviève.) b) The terrritory to be detached from the school municipality of Côte St-Rémi de Ste-Geneviève, No.4, is described as follows, to wit: 1.Subdivision No.1 of the original lot No.291 (291-1) of the parish of Ste-Geneviève; 2.Original lot No.292 of the parish of Ste-Geneviève, to deduct, however, subdivision No.44 of the original lot 292 of the parish of Ste-Geneviève; 3.Original lot No.293 of the parish of Ste-Geneviève, to deduct, however ,subdvision No.43, of the original lot No.293 of the parish of Ste-Geneviève.c) The territory to be detached from the school municipality of Ste-Geneviève No.7 and described as follows, to wit : 1.Lot No.62 of the original lot No.36 (36/ 62) of the cadastre of the parish of Ste-Geneviève; 2.Subdivision No.63 of original lot No.36 of the cadastre of the parish of Ste-Geneviève, now known and designated according to the plans filed with the Department of Lands and Forests, on November 14, 1945, as being subdisions Nos.1 to 76 inclusively, of No.63, of original lot No.36 (36/63) \u2014 1 to 36 \u2014 63 \u2014 76 inclusively; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1963, Vol.85, No.26 2125 3° Partie non-subdivisée du lot oiriginaire N° 36 de forme trianguaire ayant front sur le Boul.Lalande et borné au sud par le lot N° 42 du cadastre 292 de la paroisse de Ste-Gcneviève; à l'ouest par la subdivision N° 75 du lot N° 63 du cadastre originaire N° 36 de la paroisse de Ste-Geneviève, ayant une superficie de 3,365 pieds carrés; 4° Le lot originaire N° 41 de la paroisse de Ste-Geneviève; 5° Les lots originaires Nos 38, 39 et 40 de la paroisse de Ste-Geneviève maintenant connus et désignés suivant les plans déposés au Ministère des Terres et Forêts, le 5 avril 1945, comme étant les lots Nos 1 à 183 inclusivement du cadastre 325 et les lots 354, 455, 356 du cadastre 325 et partie du lot N° 353 du cadastre 325.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1953.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35080-o O.J.DESAULNIERS.Département des Terres et Forêts 3.Non subdivided part of original lot No.36 of triangular form with frontage on Lalande Boulevard and bounded on the south by lot No.42 of cadastre 292 of the parish of Ste-Geneviève\"; on the west, by the subdivision No.75 of lot No.63 of the original cadastre No.36 of the parish of Ste-Geneviève, habing a superficial area of 3,365 square feet; 4., Original lot No.41 of the parish of Ste-Geneviève.5.Original lots Nos.38, 39 and 40 of the parish of Ste-Geneviève, now known and designated according to the plans filed with the Dapratment of Lands and Forests, on April 5, 1945, as being lots Nos.1 to 183 inclusively of cadastre 325 and lots 354, 355, 356 of cadastre 325 and part of lot No.353 of cadastre 325.Said Order in Council to take effect on the 1st day of July, 1953.O.J.DESAULNIERS, 35080 Superintendant of Education.Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, division d'enregistrement de Champlain.Avis est par la présente donné que les lots 914-A-91, 914-A-92, 914-55, 914-56, 914-57 et 914-58 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 juin 1953.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 35081-o AVILA BÊDARD.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, registration division of Champlain.Notice is hereby given that lots 914-A-91, 914-A-92, 914-55, 914-56, 914-57 and 914-58 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, June the 10th, 1953.Department of Landi and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 35081-o Deputy Minister.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BARREAU DE L'ABITIBI \u2014 BAR OF ABITIBI Candidat pour l'admission a la pratique du droit Candidate for the admission to the practice of law Nom Name\tPrénom Surname\tAge\t1 Résidence Residence \tRoger.\t25\tVille-Marie.\t\t\t Malartic, le 18 juin 1953 \u2014 Malartic, June 18, 1953.Le Secrétaire du Barreau de l'Abitibi, J.-P.LACOURSIERE, 35105-O Secretary of the Bar of Abitibi.Lettres patentes Centre Saint-François Avis est donné qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi des évêques catholiques romains (14 George VI, chapitre 76), il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1953, constituant en corporation le \"Centre Saint-François\".Letters Patent Centre Saint-François \u2022 Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 20 of the Roman Catholic Bishops Act (George VI, chapter 76) letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June 1953, incorporating \"Centre Saint-François\". 2126 GAZETTE OFFICIELLE DE QTJÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 Le siège social de la corporation ci-haut men- The head office of the abovementioncd corpo- tionnée est situé en la cité de Salaberry-dc- ration is located in the city of de Salaberry-de- Valleyfield.Valleyfield.Donné au bureau du Secrétaire de la province Given at the office of the Provincial Secretary, le 25 juin 1953.' ' June 25th, 1953.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHESI, 35109-o JEAN BRUCHÉSI.35109 Deputy Secretary of the Province.=================== , Sièges _ sociaux Head Offices Avis list donné que la compagnie \"Pine Land Lumber Sales Ltd\", constituée en corporation en date du onzième jour d'avril 1953, et ayant son bureau principal dans la cité de Rivière-du-Loup, a établi son bureau au numéro: 336 de la rue Lafontaine en ladite cité.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Rivière-du-Loup, ce troisième jour de juin 1953.Le Secrétaire, 35089-o PAUL-YVAN MARQUIS.Filles de la Sagesse Avis du changement d'adresse du siège social de la corporation Avis est donné que la corporation \"Filles de la Sagesse\", corporation légalement constituée par une loi adoptée par la Législature de la province de Québec, sanctionnée le 12 janvier 1895, 58 Victoria, chapitre 92, et ayant eu son siège social à Montfort, province de Québec, a son siège social depuis le 12 mai 1952 à Dorval, comté de Jacques-Cartier, province de Québec.Ce siège social est donc audit endroit, à Dorval, comté de Jacques-Cartier, province de Québec.Signé ce 13e jour de juin mil neuf cent cinquante-trois.La Supérieure provinciale, (Sceau) Sr EMILE DE L'E.JÉSUS, f.d.l.s La Secrétaire provinciale, Sr JEANNE DE LA PASSION, 35094-o f.d.l.s.Soumissions Notice is hereby given that the company Pine Land Lumber Sales Ltd incorporated on the eleventh day of April, 1953, with head office in the city of Rivière-du-Loup, has established its office at number: 336 Lafontaine Street, in sai:l city.As from the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Rivière-du-Loup, this third day of June, 1953.PAUL YVAN MARQUIS, 35089 Secretary.Filles de la Sagesse Notice of change of address of the head office of the corporation Notice is hereby given that the corporation \"Filles de la Sagesse\", a corporation legally incorporated by an act adopted by the Legislature of the Province of Quebec, sanctioned January ,12th, 1895, 58 Victoria, chapter 92, and having had its head office at Montfort, Province of Quebec, has, since May 12th, 1952, its head office at Dorval, county of Jacques-Cartier, Province of Quebec.The said head office therefore, is at said location, at Dorval, at Jacques-Cartier county, Province of Quebec.Signed this thirteenth day of June nineteen hundred and fifty-three.Sr.EMILE DE L'E.JÉSUS, (Seal) f.d.l.s., .Superior Provincial.Sr.JEANNE DE LA PASSION, f.d.l.s., 35094 Provincial Secretary.Tenders Province de Québec Ville de L'Assomption (Comté de L'Assomption) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Ernest Archambault, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, L'Assomption, comté de L'Assomption, jusqu'à 8 heures p.m., mardi, le 14 juillet 1953 pour l'achat de $12,000 d'obligations de la Ville de L'Assomption, comté de L'Assomption, datées du 1er août 1953 et remboursables par séries du 1er août 1954 au 1er août 1963 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4H% Par année payable semi-annuellement les 1er août et 1er février de chaque année.Le taux d'in- Province of Quebec Town of L'Assomption (County of L'Assomption) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Ernest Archambault, Secretary-Treasurer, Town Hall, L'Assomption, county of L'Assomption, until %8 o'clock p.m., Tuesday, July 14, 1953, for the purchase of an issue of 812,000 of bonds of the Town of L'Assomption, county of L'Assomption, dated August 1st, 1953 and redeemable serially from August 1st, 1954 to August 1, 1963 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4%% Per annum, payable semi-annually on August 1st and February 1st of each year.The rate of interest may be the same for the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2127 térêt peut être, le même pour toute l'émission whole issue or it may vary according to maturi-ou il peut varier suivant les échéances.Le ties.The table of redemption is as follows: tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $12,000 \u2014 10 ans Année Capital m 1er août 1954.$ 1,000.00 1er août 1955.1,000.00 1er août 1956.1,000.00 1er août 1957.1,000.00 1er août 1958.1,000.00 1er août 1959.1,000.00 1er août 1960.1,500.00 1er août 1961.1,500.00 1er août 1962.1,500.00 1er août 1963.1,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à L'Assomption, comté de L'Assomption.Le capital et les intérêts sont payables à ,1a banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, «à Montréal, à Québec ou à L'Assomption, comté de L'Assomption.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 14 juillet 1953, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville de L'Assomption, comté de L'Assomption.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.L'Assomption (Comté de L'Assomption), ce 19 juin 1953.Le Secrétaire-trésorier, ERNEST ARCHAMBAULT.Hôtel de Ville, L'Assomption, Comté de L'Assomption, P.Q.35108-o Table of redemption \u2014 $12,000 \u2014 10 years Year Capital August 1st, 1954.S 1,000.00 August 1st, 1955.1,000.00 August 1st, 1956.1,000.00 August 1st, 1957.1,000.00 August 1st, 1958.1,000.00 August 1st, 1959.1,000.00 August 1st, 1960.1,500.00 August 1st, 1961.1,500.00 August 1st, 1962.1,500.00 August 1st, 1963.1,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at L'Assomption, county of L'Assomption.^ Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at L'Assomption, county of L'Assomption.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however,' in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, July 14, 1953, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of L'Assomption, county of L'Assomption.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.L'Assomption (County of L'Assomption), June 19, 1953.ERNEST ARCHAMBAULT, Secretary-Treasurer.Town Hall, L'Assomption, County of L'Assomption, P.Q.35108 Ventes \u2014 Loi de faillite Canada, province de Québec, district de Québec, Cour supérieure (en matière de faillite), dans l'affaire de la faillite de: Louis-Philippe Dufour, Industfiet et fermier, La Malbaie, Co.Charlevoix, Que.Failli.VENTE A L'ENCAN Avis est par les présentes donné que: JEUDI, le SEIZE JUILLET 1953, à DEUX heures p.m.seront vendus par encan public, à la porte d'église de la paroisse de St-Etienne de la Malbaie, les immeubles de cette faillite comme suit: Item A.Residence privée: Un immeuble situé à la Malbaie occupé comme résidence privée avec toutes les bâtisses dessus construites, et dépendances, étant une partie du lot 580 au cadastre officiel pour la paroisse de la Malbaie, et délimité par les lettres e, g, o.k, i, e sur un plan préparé par Joseph Eugène Lapointe, Sales \u2014 Ban)jkrupcy Act Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of: Louis-Philippe Dufour, Industrialist and farmer, La Malbaie, Cty.Charlevoix, Que.Bankrupt: AUCTION SALE Notice is hereby given that: THURSDAY, JULY SIXTEENTH, 1953, at TWO o'clock, p.m., shall be sold, by puolic auction, at the door of the parish church of St-Étienne de la Malbaie, the immoveables of this bankruptcy, as follows: Item A.Provate residence: An immoveable situate at La Malbaie, occupied as a private residence, with all the buildings thereon erected, and dependencies, being a part of lot 580 in the official cadastre of the parish of La Malbaie, the limits of which are marked by the letters e, g, o, k, i, e on a plan prepared by 2128 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 arpenteur-géomètre, en date du 20 septembre 1941 et qui est annexé à un acte de vente par Madame Archibald Gray «à M.Louis Philippe Dufour le 4 octobre 1941 et enregistré à la Malbaie, sous le N° 27734, tel que le tout a été acquis par M.Louis Philippe Dufour, aux termes de l'acte de vente ci-dessus et aussi antérieurement aux termes d'un acte de vente intervenu entre les mêmes parties, devant le même notaire le 30 juin 1939, enregistré à la Malbaie, sous le N° 26817, ensemble avec toutes les servitudes actives ou passives pouvant exister au bénéfice ou contre l'immeuble ci-dessus; à distraire toutefois toute la partie du lot 5S0-187 incluse dans la désignation ci-dessus et appartenant à M.Alcide Harvey pour l'avoir acquise par acte passé devant J.Rolland Warren, notaire, le 10 novembre 1941 et aussi aux termes d'un acte d'échange passé devant Benoît Warren notaire, le 7 mars 1940, ces deux actes intervenus entre M.Louis Philippe Dufour et M.Alcide Harvey.Nonobstant la désignation ci-dessus, la ligne sud-ouest de l'immeuble doit être tracée depuis le point K apparaissant sur le plan de M.Joseph Eugène Lapointe, dans une direction approximative sud-est jusqu'à la limite extérieure nord-ouest du chemin privé conduisant à la résidence pour ensuite longer cette limite extérieure jusqu'au point nord du lot 580-177 et ensuite se confondre avec la limite nord-est de ce dernier lot et les limites nord-ouest du lot 580-184; une servitude réelle et perpétuelle de passage au bénéfice du lto 580 subdivisé et non subdivisé c'est-à-dire au bénéfice de tous les terrains se trouvant au sud de la route conduisant à la résidence, sera constituée comme affectant toute la partie de la route faisant front au nord-est aux lots 580-177 et 580-191 permettant d'utiliser cette route sur toute sa largeur comme chemin public pour ensuite se diriger vers le sud-ouest vers les fonds dominants.' Item B.Maison du fermier (2 logements): Un immeuble situé à La Malbaie, en le comté de Charlevoix, avec maison à deux (2) logements dessus construits, étant le lot cent soixante-dix-sept de la subdivision officielle d'une partie du lot originaire cinq cent quatre-vingt (177-580) au cadastre officiel pour la paroisse de la Malbaie.(Ensemble avec un droit de passage pour communiquer depuis l'immeuble jusqu'à la route publique, lot 580-184) (Cet immeuble appartient à M.Louis-Philippe Dufour pour l'avoir acquis pour une plus grande étendue de dame J.Archibald Gray par acte devant Me.J.Rolland Warren, notaire, en date du 24 octobre 1947, enregistré sous le N° 31351.) Item C.Arrondissement St-Philippc: Certains lots vacants connus sous le nom de \"Arrondissement St-Philippe\" étant les lots 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 et 28 de la subdivision officielle du lot originaire N° 577 au cadastre officiel pour la paroisse de La Malbaie, ensemble avec toutes les servitudes passives pouvant les affecter et toutes les servitudes actives pouvant exister en leur bénéfice et notamment un droit de passage dans un chemin privé permettant de communiquer depuis cet arrondissement jusqu'au chemin public: le lot 11-577 ci-dessus sera cependant vendu sous réserve d'une servitude de passage, à pieds ou en voiture de toute sorte, de passage de tuyaux d'aqueduc, d'égout, de ligne électrique et téléphonique, et généralement de tout ce qui peut être considéré comme une utilité publique, au bénéfice de tous les autres lots de l'arrondisse- Joseph Eugène Lapointe, surveyor, bearing date the 20th day of September, 1941 and which is annexed to a deed of sale by Madame Archibald Gray to Mr.Louis Philippe Dufour, on October 4, 1941 and registered at La Malbaie, under No.27734, as the whole was acquired by Mr.Louis Philippe Dufour, on the terms of the above deed of sale, and also previously to the terms of a deed of sale entered into between the same parties, before the same notary on June 30, 1939, registered at La Malbaie, under No.26817, together with all the active or passive servitudes which may exist to the benefit or against the above immoveable; to subtract, however, all that part of lot 580-187 included in the designation hereinabove and belonging to Mr.Alcide Harvey by having acquired it by deed passed before J.Rolland Warren, notary, on November 10, 1941, and also on the terms of a deed of exchange passed before Benoît Warren, notary on March 7, 1940, both these deeds having been entered into by Mr.Louis Philippe Dufour and Mr.Alcide Harvey.Notwithstanding the hereinabove designation, the southwestern line of the immoveable should be traced from point K appearing on the plan of Mr.Joseph Eugène Lapointe, in an approximately southeasterly direction as far as the exterior boundary northwest of the private road leading to the residence which then continues along this exterior boundary to a point north of lot 580-177 and then blends itself with the boundary northeast of this latter lot and the northwestern limits of lot 580-184 a real and pertpetual servitude of right-of-way for the benefit of lot 580 subdivided and unsubdivided, that is to say for the benefit of all the lots of land to be found south of the road leading to the residence, shall be constituted as affecting all that part of the road fronting the northeast of lots 580-177 and 580-191 allowing the use of this road upon its entire width as a-public road which then leads towards the south west toward the main landholds.Item B.Farmers House (2 tenements): An immoveable situate at La Malbaie, in the county of Charlevoix, with a house of two (2) tenements thereon erected, being lot one hundred and seventy-seven of the official subdivision of a part of the original lot five-hundred and eighty (177-580) of the official cadastre for the parish of La Malbaie.(Together with a right of way to communicate with the immoveable as far as the public highway, lot 580-184) (This immoveable belongs to Mr.Louis-Philippe Dufour who acquired it to extend the holding from Dame J.Archibald Gray by deed before Me.J.Rolland Warren, notary, bearing date October 24, 1947, registered under No.31351).Item C.\"Arrondissement St-Philippe\", Certain vacant lots known under the name of \"Arrondissement St-Philippe\" being lots 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 and 28 of the official subdivision of the original lot No.577 of the official cadastre for the parish of La Malbaie, together with all the passive servitudes by which they may be affected and all the active servitudes which may exist to their benefit and particularly a right of way in the private road allowing communications from this \"arrondissement\" to the public highway; lot 11-577 hereinabove will, however, be sold under reserve of a right-of-way servitude, afoot or by traction of any king, for the passing of pipes for aqueduct or sewer, electric or telephone lines, and in general, for anything that may be considered in the nature of a public utility for the benefit of the other lots of the \"arrondissement St-Philippe\", that is to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.20 2129 ment St-Philippe, c'est-à-dire de la subdivision du lot 577, affectant le lot ci-dessus.La servitude ci-dessus deviendra cependant nulle le jour ou la Corporation municipale de La Malbaie ouvrira une rue pour desservir cet arrondissement.Item D.Seigneurie: Plan A: Partie se trouvant au nord-ouest du C.N.R.Une certaine étendue de terrain étant le lot 625 et une partie du lot 580 au cadastre officiel pour la paroisse de La Malbaie, bornée vers le nord-est par le Murray Bay Golf Club les chemins de fer nationaux et par les lots 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598A, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616,617,618,619,620,621,622- vers le nord-ouest par le lot 625- vers le sud-ouest par le rang St-Charles, la rive sud de la Rivière Mailloux, le Murray Bay Golf Club: vers le sud-est par le lot 723, tel que le tout est décrit au long dans une description technique préparée par M.Jacques Éthier, arpenteur-géomètre, et montrée sur un plan A, qui sont annexés à un acte de vente par dame J.Archibald Gray à M.Louis-Philippe Dufour, passé devant J.R.Warren, notaire, le 24 octobre 1947, et enregistré sous le N° 31351, avec en outre une partie du lot 584 au même cadastre, tel qu'acquise de M.François Martel par M.Louis-Philippe Dufour en un acte d'échange passé devant J.Elias Gagné, notaire, le 16 janvier 1948, enregistré à La Malbaie sous le N° 31622, à l'original duquel est annexé un plan préparé par Jacques Éthier, arpenteur, en date du 2 décembre 1947, une partie de l'immeuble ci-dessus décrit a fait l'objet d'une subdivision officielle et est aujourd'hui connu comme étant les lots 185, 186, 182, 183-1, 183, 184, 177, 178, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,208,209,210,211, 212 et 213 de la subdivision officielle d'une partie du lot originaire 580 au cadastre officiel de la paroisse de La Malbaie.A distraire de l'immeuble décrit ci-dessus: 1.Une partie du lot 580 cédée par M.Louis-Philippe Dufour à M.François Martel par l'acte d'échange dont il est ci-dessus fait mention et comprise cette partie entre les lettres a, b, c, f, sur le plan annexé audit acte.2° Les lots 177, 178, 179, 180, 182, 184, 186, 185, 189 et 183-1 de la subdivision officielle d'une partie du lot 580.3° Les droits de propriété de M.Edward Dug-gan Gray lui provenant d'un acte de vente qui lui a été consenti par M.Louis-Philippe Dufour le 24 octobre 1947 par acte passé devant Me.J.Rolland Warren, notaire, et aussi les droits de coupe de bois de MM.Sylvio Asselin et Aurèle Harvey résultant d'un acte de vente consenti à ces derniers par M.Louis-Philippe Dufour devant J.Elias Gagné, notaire, le 18 novembre 1950.Seigneurie: Plan B: Partie se trouvant à l'arrière de l'usine Coca-Cola.Une certaine étendue de terrain étant partie du lot 575 au cadastre officiel pour la paroisse de La Malbaie, bornée vers le nord-est aux lots 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la subdivision officielle du même lot 575 et aussi à une partie non subdivisée de ce même lot: vers le nord-ouest au lot 575-1 : vers le sud-est au ruisseau Théodore ou la Rivière Mailloux et vers le sud-ouest par une ligne indiquée par les lettres t, s.r, q, p sur un plan préparé par M.Jacques Éthier, arpenteur-géomètre, et qui est annexé à un acte de vente par Mme J.Archibald Gray à M.Louis-Philippe say for the subdivision of lot 577, affecting the hereinabove lot.The servitude hereinabove shall, however, become void on whatever day the municipal corporation of La Malbaie shall open a street to serve this \"arrondissement\".Item D.Seigniory: Plan A: That part which is northwest of the C.N.R.A certain breadth of land being lot 625 and a part of lot 580 of the official cadastre for the parish of La Malbaie, bounded on the northeast by the Murray Bay Golf Club, the Canadian National Railways and by lots 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598A, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622; on the northwest by lot 625; on the southwest, by Range St-Charles, the south bank of the Mailloux River, the Murray Bay Golf Club: on the southeast, by lot 723, as the whole is fully described in a technical description prepared by Mr.Jacques Ethier, surveyor, and shown on plan A, which are annexed to a deed of sale by Dame J.Archibald Gray to Mr.Louis-Philippe Dufour, passed before J.R.Warren, notary, October 24, 1947, and registered under No.31351, with, moreover, a part of lot 584 of the same cadastre, as acquired from Mr.François Martel by Mr.Louis-Philippe Dufour in a deed of exchange passed before J.Elias Gagné, Notary, on January 16, 1948 registered at La Malbaie under No.31622, on the original of which is annexed a plan drawn up by Jacques Ethier, surveyor, bearing date December 2, 1947, a part of thé immoveable hereinabove described having been the object of an official subdivision and is today known as being lots 185, 186, 182, 183-1, 183, 184, 177, 178, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 and 213 of the official subdivision of a part of original lot 580 of the official cadastre of the parish of La Malbaie.To subtract from the immoveable hereinabove described 1.A part of lot 580 ceded by Mr.Louis-Philippe Dufour to Mr.François Martel by the deed of exchange mention of which has hereinabove been made and comprised therein that part between the letters a.b, c, f.on the plan annexed to the said deed.2.Lots 177, 178, 179, 180, 182, 184, 186, 185, 189 and 183-1 of the official subdivision of one part of lot 580.3.Property rights of Mr.Edward Duggan Gray acquired by him through a deed of s lie given him by Mr.Louis-Philippe Dufour on October 24, 1947, by deed passed before Me J.Rolland Warren, Notary, and also timber cutting rights for Messrs.Sylvio Asselin and Aurèle Harvey resulting from a deed of sale given to the latter by Mr.Louis Philippe Dufour before J.Elias Gagné, notary, on November 18, 1950.Seigniory: Plan B: That part which is in rear of the Coca-Cola factory.A certain breadth of land, being part of lot 575 on the official cadastre for the parish of La Malbaie, bounded on the northeast by lots 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of the official subdivision of the same lot 575 and also by an unsub-divided part of this same lot; on the northwest by lot 575-1; on the southeast, by the Theodore Brook or the Mailloux River and on the southwest by a line shown by the letters t.s, r, q, p on a plan drawn up by Mr.Jacques Ethier, surveyor, and which is annexed to a deed of sale by Mrs.J.Archibald Gray to Mr.Louis Philippe Dufour, 2130 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, .Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 Dufour, passé devant Me.J.Rolland Warren, notaire, le 24 octobre 1947 et enregistré sous le N° 31351.L'immeuble ci-dessus désigné comprend tout l'immeuble acquis par M.Louis-Philippe Dufour aux termes de l'acte ci-dessus et décrit au plan B y annexé moins les parties vendues à MM.Dor-ville et Lucien Harvey, à M.Gérard Fortin et au docteur Paul-Émile Paquin, et à distraire aussi, s'ils affectent la partie restante, les droits réservés par Mme.J.Archibald Gray sur une lisière de 25 pieds mesurée depuis le niveau moyen des hautes eaux du fleuve St-Laurent et plus longuement décrit en l'acte de vente ci-dessus en date du 24 octobre 1947, ensemble avec toutes les servitudes passives ou actives pouvant exister contre ou au bénéfice de cet immeuble.Seigneurie: Plan C: Partie se trouvant entre le C.N.R.et le chemin public Une certaine étendue de terrain de forme irrégulière étant partie du lot 580 au cadastre officiel pour la paroisse de La Malbaie, bornée vers le nord-est par le lot 580-128: vers le sud-est par le chemin public; vers le sud-ouest à partir du lot 580 et vers l'ouest et le nord-ouest à la propriété du Canadian National, tel que le tout est décrit au long dans une description technique préparée par M.Jacques Éthier, arpenteur-géomètre, et montrée sur un plan C, qui sont annexés à un acte de vente par Mme J.Archibald Gray à M.Louis-Philippe Dufour, passé devant J.R.Warren, notaire, le 24 octobre 1947, et enregistré sous le N° 31351; à distraire cependant le lot 580-188, propriété de M.Gérard Forgues, acquis le premier septembre 1948 par acte devant J.Elias Gagné, notaire, et aussi les parties acquises par MM.Ernest Bruyère et J.René Côté, le premier par acte devant Me.Benoit Warren, notaire le 3 juin 1948 et le second par acte devant J.Elias Gagné, notaire le 18 août 1948, ensemble avec toutes les servitudes actives et passives pouvant exister au bénéfice ou contre l'immeuble ci-dessus, et plus spécialement sujette aux servitudes comprenant prohibition de construire, et autres, tel que constituée en l'acte de vente par J.Archibald Gray à M.Louis-Philippe Dufour, devant J.R.Warren, notaire, le 24 octobre 1947 et en l'acte de vente ci-dessus en faveur de Ernest Bruyère.ItemE.: Tous les droits que peut posséder M.Louis-Philippe Dufour dans une route au chemin étant partie du lot 575 au cadastre officiel de la paroisse de La Malbaie conduisant aux propriétés de MM.Camille Dufour et Paul X.Laberge, borné pour partie à la propriété de Mme J.Archibald Gray ou représentants et pour les autres parties aux propriétés de MM.Adélard Potvin, Camille Dufour et Paul X.Laberge.Item B.Ruisseau Théodore: Tous les droits que peut avoir M.Louis-Philippe Dufour dans le cours d'eau connu sous le nom de \"Ruisseau Théodore\" qui traverse différents lots de la Seigneurie, et tels qu'acquis de dame J.Archibald Gray par un acte de vente à lui consenti le 24 octobre 1947 par acte devant Me J.R.Warren, notaire, et enregistré sous le N° 31351.Ces item seront offerts en vente aux plus hauts et derniers enchérisseurs à charge cependant des rentes et autres servitudes actives et passives qui peuvent exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.passed before Me J.Rolland Warren, Notary, on October 24,1947, and registered under No.31351.The immovable hereinabove designated takes in all of the immoveable acquired by Mr.Louis-Philippe Dufour according to the terms of the deed hereinabove and described on plan B annexed thereto less those parts sold to Messrs.Dorville and Lucien Harvey, to Mr.Gérard Fortin and to Doctor Paul-Emilc Paquin, and to subtract also, should they affect that part which remains, the rights reserved by Mrs.J.Archibald Gray along a strip of land of 25 feet measured after the average level of the high water tides of the St.Lawrence River, and more fully described in the deed of sale hereinabove dated October 24, 1947, together with all the active or passive servitudes which may exist against or in favor of this immoveable.Seigniory: Plan C: That part which is found between the C.N.R.and the Public Highway.A certain breadth of land of irregular form being part of lot 580 on the official cadastre for the parish of La Malbaie, bounded on the northeast, by lot 580-128; on the southeast, by the public highway; on the southwest, to part of lot 580 and on the west and the northwest to the property of the Canadian National, as the whole is described at length in a technical description drawn up by Mr.Jacques Ethier, surveyor, and mounted on plan C, which are annexed to a deed of sale by Mrs.J.Archibald Gray to Mr.Louis-Philippe Dufour, passed before J.R.Warren, Notary, on October 24, 1947, and registered under No.31351; to subtract, however, lot 580-188, property of Mr.Gérard Forgues, acquired September first, 1948 by deed before J.Elias Gagné, Notary, and also the parts acquired by Messrs.Ernest Bruyère and J.René Côté, the first by deed before Me Benoît Warren Notary, on June 3, 1948 and the second by deed before J.Elias Gagné, Notary, on August 18, 1948, together with all the active and passive servitudes which may exist in favor or against the hereinabove immoveab'e, and more especia\"y subject to the servitudes comprising the prohibition the build, and others, such as incorporated in the deed of sale by J.Archibald Gray to Mr.Louis-Philippe Dufour, before J.R.Warren, Notary, on October 24, 1947, and in the deed of sale in favor of Ernest Bruyère.Item E.: All rights which Mr.Louis-Philippe Dufour may possess in a road to the highway being part of lot 575 on the official cadastre of the parish of La Malbaie, leading to properties of Messrs.Camille Dufour and Paul X.Laberge, bounded in part by the property of Mrs.J.Archibald Gray or representatives and for the other parts to the properties of Messrs Adélard Potvin, Camille Dufour and Paul X Laberge.Item F.Theodore Brook: All rights which Mr.Louis-Philippe Dufour may have in the watercourse known under the name of \"Theodore Brook\", which crosses different lots of the Seigniory, and as acquired from Dame J.Archibald Gray by a deed of sale given him on October 24, 1947 by deed before Me J.R.Wnrrcn, Notary, and registered under No.31351.These items shall be offered for sale to the highest and last bidders, subject, however, to the rents and other active and passive servitudes, which may exist.Titles and certificates may be seen at any time at the offices of the undersihned trustees. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.86, No.26 2131 Cette vente est faite conformément aux articles 716 et 717 du Code de Procédure Civil et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: COMPTANT Québec, ce 8 juin 1953.Les Syndics, R.ERNEST LEFAIVRE, JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE.Bureaux: 111 Côte de la Montagne, Québec, Que.35025-24-2-o Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, \"En»faillite\" No.240.Dans l'affaire de la faillite de: Leopold Roussin, Montréal, P.Q., débiteur et Claude Perras, syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Désignation: Un emplacement situé dans la ville de Rigaud, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro soixante quatre (Ptie N° 64) aux plan et livre de renvoi officiels du village de Rigaud, mesurant cinquante pieds de largeur à partir de l'emplacement appartenant à Mde Henri Lalonde, par cent vingt cinq pieds de profondeur à partir de la rue Roussin, mesure anglaise plus ou moins, borné en front par la rue Roussin, en arrière par le résidu du lot N° 64, appartenant à M.D.Roussin d'un côté par l'emplacement de Mde Henri Lalonde et de l'autre côté à l'emplacement de M.Jules Bélanger, avec toutes les bâtisses dessus érigées.Sera vendu en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, pour le district de Montréal, (en faillite) rendu le 16e jour de juin 1953, à l'enchère publique suivant la loi, pour ladite vente avoir l'effet du décret forcé au terme du code de procédures civiles, à la porte de l'église paroissiale du village de Rigaud, JEUDI le VINGT-TROIS JUILLET 1953, à ONZE heures de l'avant-midi, heure avancée.Conditions: comptant.En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du gouvernement de 2^% conformément à la loi.Pour autres renseignements et cahier des charges, s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 16e jour de juin 1953.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: Perras & Perras, Syndics, 4, Notre Dame est, Montréal, P.Q.35076-25-2-o Province de Québec, district de Joliette, Cour supérieure (En matière de faillite), N° 466.In re: Henri Bohémier, courrier, de Saint-Henri de Mascouche, district de Joliette, débiteur.Avis est pur les présentes donné que MERCREDI, le VINGT-NEUVIÈME jour de JUILLET 1953, à DIX heures de l'avant-midi, à la porte de l'église paroissiale de Saint-Henri de Mascouche, district de Joliette, seront vendus, par encan public, au plus haut et dernier enchérisseur, les immeubles suivants cédés par le débiteur, en cette cause, savoir: Un emplacement situé en la paroisse de Saint-Henri de Mascouche, comté de l'Assomption, connu et désigné comme étant les lots numéros deux cent soixante-huit et deux cent soixante- The said sale is made in conformity with articles 716 and 717 of the Code of Civil Procedure and also section 55 of the Bankruptcy Act 1949, This sale will have the effect of a Sheriff's sale.Conditions of sale: CASH Quebec, June 8, 9153.R.ERNEST LEFAIVRE, JOSEPH MARMETTE & RENE LEFAIVRE, Trustees.Office: 111 Mountain Hill, Quebec, Que.35025-24-2 Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, \"Sitting in Bankruptcy\" No.240 In the matter of: Leopold Roussin, Montreal, P.Q., debtor, and Claude Perras, trustee.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit: Designation: An emplacement situate in the town of Rigaud, known and designated as forming part of lot number sixty-four (Pt.No.64) on official plan and in the book of reference of the village of Rigaud, measuring fifty feet in width starting from the emplacement belonging to Mrs.Henri Lalonde, by one hundred and twenty-five feet in depth from Roussin Street, English measure, more or less, bounded in front by Roussin Street, in rear by the residue of lot No.64, belonging to Mr.D.Roussin on one side by the emplacement of Mrs.Henri Lalonde and on the other side by the emplacement of Mr.Jules Bélanger, with all the buildings thereon erected.Will be sold in virtue of a judgment of the Superior Court, for the district of Montreal, (in bankruptcy) rendered the 16th day of June, 1953, at public auction according to law, so that the said sale may have the effect of a sheriff's sale according to the terms of the Civil Code of Procedure, at the parochial church door of the village of Rigaud, THURSDAY, JULY TWENTY THREE, 1953, at ELEVEN o'clock in the forenoon, Daylight Saving Time.Conditions: cash.Over and above the purchase price, the purchaser must pay the government tax of 2^%, according to law.For other information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this 16th day of June, 1953.CLAUDE PERRAS, Office of: Trustee.Perras & Perras, Trustees, 4, Notre-Dame Street, East, Montreal, P.Q.35076-25-2 Province of Quebec, district of Joliette, Superior Court (Sitting in Bankruptcy), No.466.Re: Henri Bohémier, courier, of Saint-Henri de Mascouche, district of Joliette, debtor.Notice is hereby given that on WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH of JULY, 1953, at TEN o'clock in the forenoon, at the parochial church door of Saint-Henri de Mascouche, district of Joliette, the following immoveables transferred by the debtor, in this case, shall be sold by public auction to the last and highest bidder, to wit: An emplacement situate in the parish of Saint-Henri de Mascouche, county of l'Assomption, known and designated as lots number two hundred and sixty-eight and two hundred and 2132 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 26 neuf (Nos 268 et 269) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de ladite paroisse de Mascouche, avec bâtisses y érigées.Un emplacement situé en ladite paroisse de Saint-Henri de Mascouche, connu et désigné comme étant le lot de terre numéro deux cent soixante-douze (272), aux plan et livre de renvoi officiels du susdit cadastre, comprenant environ vingt-neuf perches et cent huit pieds en superficie, et borné en front par le chemin public, en arrière par Jean Bte Renaud ou représentants, d'un côté par la Montée de la Pachane et de l'autre côté par dame veuve J.Bte Renaud ou représentants, avec toutes les bâtisses dessus érigées; à distraire cependant dudit lot numéro 272, la partie que Sieur Zenon Dugas a vendu au Gouvernement de la province de Québec, suivant acte de vente passé devant le notaire P.A.Séguin, le dix-neuf octobre mil neuf cent trente-cinq, enregistré à l'Assomption, sous N° 52157 pour la route Montréal-Terrebonne-Saint-Donat.Ainsi que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.L'immeuble en premier lieu désigné comprenant les numéros 268 et 269 sera vendu séparément et l'immeuble étant le numéro 272 sera vendu seul.Conditions de la vente: U sera exigé de tout offrant ou enchérisseur, sur chaque offre ou enchère, un dépôt représentant 10% de ladite offre ou enchère, en rapport avec l'immeuble étant les numéros 268 et 269 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Henri de Mascouche et un dépôt de 20% en rapport avec l'immeuble étant le numéro 272 dudit cadastre.Les acquéreurs devront prendre les immeubles dans l'état où ils sont présentement, sans aucune garantie, sauf celles des faits personnels du syndic.Cette vente faite d'après les articles 55 et suivants de la Loi de faillite équivaut à une vente faite par le Shérif.22 juin 1953.Le Syndic-Autorisé, ALBERT LAMARRE.10, rue Saint-Jacques Est, Montréal.35104-26-2-O Canada, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, Cour Supérieure N° F-20.(Division de faillite) dans l'affaire de la faillite de: André Sauvé, commis, de Noranda, district de Rouyn-Noranda, failli, et Albert Lamarre, Syndic.ADMINISTRATION SOMMALRE Avis est par les présentes donné qu'Albert Lamarre, en sa qualité de Syndic de la faillite d'André Sauvé, vendra, au plus haut enchérisseur, à DEUX heures de l'après-midi, le QUATORZE AOÛT 1953, au munéro civique 637, de la rue Chaussé, cité de Rouyn, district de Rouyn Noranda, l'immeuble décrit ci-après: 1° Un certain lot de terre connu et désigné comme étant le lot numéro cent vingt-neuf (129), du bloc deux cent un (201), canton de Rouyn, sauf cependant une certaine partie de terrain triangulaire et située dans le coin sud-est dudit lot, mesurant trente-huit pieds partant du coin sud-est dudit lot et allant dans une direction nord en suivant le côté est du dit lot, et cinquante-cinq pieds partant du même coin sud-est du sixty-nine (Nos.268 and 269) on the official plan and book of reference of the cadastre of the said parish of Mascouche, with buildings erected thereon.An emplacement situated in the said parish of Saint-Henri de Mascouche, known and designated as lot of land number two hundred and seventy-two (272), on the official plan and book of reference of the abovementioned cadastre, including about twenty-nine rods and one hundred and eight feet in area, and bounded in front by the public highway, in the rear by Jean Bte Renaud or his representatives, on one side by \"la Montée de la Pachane\", and on the other side by Dame Jean Bte Renaud, widow, or her representatives, with all buildings erected thereon; to deduct though from said lot number 272, the part which Sieur Zenon Dugas sold to the Government of the Province of Quebec, according to a deed of sale passed before P.A.Seguin, notary, on the nineteenth of October, one thousand nine hundred and thirty-five, registered at l'Assomption, under No.52157 for the Montreal-Terrebonne-Saint-Donat highway.As the whole actually stands, 'with servitudes both active and passive, apparent and un-apparent, attached to said immoveables.The immoveable firstly mentioned, including numbers 268 and 269 shall be sold separately, and the immoveable bearing number 272 shall be sold alone.Conditions of sale: There shall be exacted from every bidder, and on every bid a deposit equal to 10% of the said bid, respecting immoveable bearing numbers 268 and 269 of the official cadastre of the parish of Saint-Henri de Mascouche, and a deposit of 20% on that of the immoveable bearing number 272 of said cadastre.The buyers shall accept the immoveables in their present status, without any guarantee, save those made by trustee personally.This sale carried out in accordance with articles 55 and the following of the Bankruptcy Act is equivalent to a sale by Sheriff.June 22, 1953.ALBERT LAMARRE, Authorized-Trustee.10 St.James Street, East, Montreal.35104-26-2 Canada, Province of Quebec, district of Rouyn-Noranda, Superior Court (Bankruptcy Division) No.F-20 in the matter of: André Sauve, clerk, of Noranda, district of Rouyn-Noranda, Bankrupt, and Albert Lammarre, Trustee.SUMMARY ADMINISTRATION Notice is hereby given that Albert Lamarre, in his quality of trustee to the bankruptcy of André Sauvé, will sell to the highest bidder, at TWO o'clock in the afternoon on AUGUST FOURTEENTH, 1953, at civic number 637 Chausse Street, City of Rouyn, district of Rouyn-Noranda, the immoveable property hereinafter described: 1.That certain Lot of land known and designated as being lot number one hundred and twenty-nine (129), Block two hundred and one (201) township of Rouyn, excepting however a certain portion of triangular land situated at the south east corner of the said lot, measuring thirty-eight feet from the south-east corner of the said lot towards the North along the East QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1953, Vol.85, No.26 2133 dit lot et allant dans une direction ouest en suivant le côté sud du dit lot; 2° Une certaine partie de lot faisant partie du lot numéro cent trente (130), du Bloc deux cent un (201), Canton de Rouyn, étant une partie triangulaire située dans le coin nord-ouest du dit lot et mesurant trente-cinq pieds partant du coin nord-ouest du dit lot et allant dans une direction Est en suivant le côté nord du dit lot et trente pieds partant du même coin nord-ouest et allant dans une direction sud-est en suivant le chemin Bellecombe.Le tout avec bâtisses dessus constriutes, circonstances et dépendances et tel qu'indiqué à un plan préparé par les parties à un acte de vente passé devant le notaire, Me.Paul E.Morissette, en date du 1 juin 1949, minute 1151 et annexé à tel acte de vente.La dite vente aura l'effet du décret, conformément à l'ordonnance rendue par l'Honorable Juge Henri Drouin, J.C.S., le 21 février 1953.Rouyn, Québec, 15 juin 1953.Les procureurs Syndic, Albert Lamarre, 35095-26-2-O FORTIN GRIMARD & RYAN.Vente pour taxes side of the said lot, and fifty-five feet from the same south-east corner of the said lot towards a westerly direction along the south side of the said lot; 2.A certain portion of land forming part of lot number one hundred and thirty (130), of Block two hundred and one (201) township of Rouyn, being a triangular portion situated at the north-west corner of the said lot and measuring thirty-five feet from the north-west corner of the said lot towards an easterly direction along the north side of the said lot and thirty feet from the same northwest corner, towards a southeast direction along Chemin Bellecombe.The whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies and as indicated on a plan prepared by the parties to a deed of sale passed before Me Paul E, Morissette under date of June 1, 1949, number 1151 of his minutes, and annexed to the said deed of sale.The said sale will have the effect of a Sheriff's sale, in conformity with the judgment rendered by Honorable Henri Drouin, J.S.C., on February 21, 1953.Rouyn, Que., June 15th, 1953.FORTIN, GRIMARD & RYAN, Attorneys for the trustee, 35095-26-2-o Albert Lamarre.Sale for Taxes Village de Senneville Village of Senneville Avis public est par les présentes donné que conformément à un arrêté en conseil en date du 5 Juin 1953, le secrétaire-trésorier de Village de Senneville de comté Jacques Cartier vendra à l'enchère le TRENTE ET UN jour de JUILLET 1953 à DIX heures de l'avant-midi, au bureau du conseil, 35 Rue Senneville, Village de Senneville, de la manière prescrite par la loi, les immeubles suivants sur lesquels les taxes municipales et scolaires n'ont pas été payées.Public notice is hereby given that pursuant to an order of the Council made on June 5th 1953 the Secretary-Treasurer of the Village of Senneville in the County of Jacques Cartier will, on the 31st day of JULY 1953 at TEN o'clock in the forenoon at the office of the Council, 35 Senneville Road, Village of Senneville sell at-public auction in the manner prescribed by law the following immoveables on which the municipal and school taxes assessed have not been paid Nom du propriétaire\tDescription\tTaxes non-payéea Name of owner\tDescription\tUnpaid taxes \tSubdivision 399, lot N° 23, paroisse de Sto-Anne \u2014 Lot 23, Subdivision 399, parish of Ste-Anne.\t$ 3.19 \t\t Donné à Senneville, ce 22e jour de juin, 1953.Le Secrétaire-Trésorier, 35106-26-2-o V.H.GRAHAM.Given at Senneville, this 22nd day of June 1953.V.H.GRAHAM, 35106-26-2-o Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Canada, Province de Québec, District d'Abitibi Cour Supérieure, / T3 AOUL BISSON, contrac-N° V-2087.< JLv teur de Louvicourt, dis-( trict d'Abitibi, demandeur; SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Canada, Province of Quebec, District of Abitibi Superior Court, ( \"D AOUL BISSON, contrac-No.V-2087.< ^ tor of Louvicourt, dis-1 trict of Abitibi, plaintiff; vs 2134 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1953, Tome 85, N° 2G vs FLORIAN PEPIN, journalier de Senneterre, district d'Abitibi, défendeur.Les droits acquis sur le lot numéro 61, du rang 6, Canton Pascalis, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église, située au lac Obaska, Canton Pascalis, le JEUDI, SEIZE JUILLET 1953, à DEUX heures de l'après-midi, (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS Amos, le 3 juin 1953.34986-23-2-o FLORIAN PEPIN, labourer of Senneterre, district of Abitibi, defendant.The rights acquired on lot number 61, Range VI, township of Pascalis, with buildings erected thereon, and appurtenances.To be sold at the church door situate at Lake Obaska, township of Pascalis, THURSDAY, JULY SIXTEENTH, 1953, at TWO o'clock in the afternoon, (Daylight saving time).FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, June 3, 1953.34986-23-2 HULL District de Hull Cour Supérieure, / \\ vfURRAY M.BAYNE, de N° 2082.1 -IVl la Ville de Bucking-( ham, assistant-gérant, demandeur, vs GÉRARD CHEN1ER, autrefois de la ville de Buckingham et maintenant de lieux inconnus, défendeur.1° Ce certain morceau de terrain de forme triangulaire formant partie du lot N° 252 (deux cent-cinquante-deux) de la ville de Buckingham, suivant son cadastre officiel et étant le coin sud-ouest dudit lot.2° Cet autre morceau de terrain également de forme triangulaire formant partie du lot 253 (deux cent cinquante-trois) de la ville de Buckingham, suivant son cadastre officiel et étant le coin sud-ouest dudit lot, avec toutes les bâtisses dessus érigées.Les dits deux morceaux de terrain formant ensemble qu'un seul emplacement, mesurant 97' dans sa ligne nord, 71' dans sa ligne sud et 80' dans sa ligne ouest, le tout plus ou moins.et bornés comme suit: \u2014 au nord et à l'est par l'emprise du C.P.R.; au sud par la propriété de Florimond Strévez ou lot 254 et à l'ouest partie par la propriété d'Eudore Tremblay ou le lot N° 305 et partie par la propriété d'Armand Cadieux ou le lot N° 304, avec et comprenant un droit de passage gratuit et perpétuel sur et à travers toute la longueur dudit lot N° 305 possédé par Eudore Tremblay, de manière à permettre la communication entre la rue Pine et la propriété ci-dessus mentionnée.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St.Grégoire de Naziance, dans la ville de Buckingham, le TREIZIÈME jour de JUILLET, 1953, à DEUX heures de l'après-midi (heure avancée).Bureau du Shérif.Le Shérif, 34987-23-2 R.ST-PIERRE.JOLIETTE Fieri Facias de Bonis et de Terris Province de Québec, district de Joliette Cour Supérieure, / t A CAISSE POPULAIRE N° 10906 < l/ DE ST-JACQUES DE ( MONTCALM, corps politique et incorporé ayant son siège social dans le village de St-Jacques, district de Joliette, demanderesse vs ALAIN DESROCHERS, de la paroisse de St-Jacques de l'Achigan, district de Joliette, défendeur: Comme appartenant et étant en la possession du défendeur, l'immeuble ci-après mentionné et décrit, savoir: La juste moitié nord-ouest du lot N° 308 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jacques de l'Achigan, mesurant en superficie 45 arpents.Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse de St-Jacques de l'Achigan, au village HULL District of Hull Superior Court, / \\ yfURRAY M.BAYNE, of No.2082.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.