Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 8 (no 32)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1953-08-08, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 85, N° 32 2451 Vol.85, No.32 \t¦\t \t\tHi \t¦\t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 8 août 1053 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1953.Québec, le 8 juin 1953.L'Imprimeur de la Reine.35004-24-12-0 RÉDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, August 8th, 1953 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1953.Quebec, this 8th, of June 1953.REDEMPTI PARADIS, 35004-24-12-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2452 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1058, Tome 85, N° 82 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, choque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.(5° Toute remise doit être faite à Tordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat «le banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Quebec est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi A condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas.l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de relarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc: Premiere insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 26G lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre: le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, REDEMFri PARADIS.Hotel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898\u2014 1-52 the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order ot the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning: but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents' or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, oneroui costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etoi s First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.\u2022 Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number: the second to that of the edition of the Gatette for the first insertion: the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u20141-52 Lettres patentes (P.G.13534-53) Acme Barrel Manufacturing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit juin 1953, constituant en corporation: Ben Schecler, Moses Moscovilch, avocats, Margaret McMartin, fille majeure, commis, Raymonde Lutterman, veuve, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Letters Patent (A.G.13534-53) Acme Barrel Manufacturing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1953, incorporating: Ben Schecter, Moses Moscovitcfi, advocates, Margaret McMartin soinster, clerk, Raymonde Lutterman, widow clerck, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.85, No.82 2453 Exercer le commerce de tonneliers; manufacturer et faire le commerce de barils, ffits, emballages, tonneaux et autres produits semblables, soit fabriqués de bois, métal ou autres substances, sous le nom de \"Acme Barrel Manufacturing Inc.\", avec un capital de S40.000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité des Trois-Itivières, district judiciaire des Trois-Bivières.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.14132-53) Aircraft Welding and Sheet Metals Co.* Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois juin 1953, constituant en corporation: Paul Ranger, J.-Jacques Beauchemin, avocats, J.-Philippe Beaidac, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter et gérer des fonderies, des moulins, des manufactures pour la fabrication de tous morceaux lourds et/ou légers, de moteurs pour avions, autos, engins; faire, installer des systèmes de ventilation et des systèmes de chauffage a air chaud, sous le nom de \"Aircraft Welding and Sheet Metals Co.Limited\", avec un capital de $49,000, divisé en 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de §100 chacune et en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de §100.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire -le Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.(P.G.13535-53) Alwin Refrigeration & Appliance Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la .province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit juin 1953, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Briskin, avocats, Sybil Schechter, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, manufacturer et autrement faire le commerce de radios, outillage de télévision, dispositifs électriques, appliques, appareils de réfrigération, sous le nom de \"Alwin Refrigeration & Appliance Co.Ltd.\", avec un capital de $60,000, divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune et 200 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.14326-53) Arthur Sirois, LtC*e Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été To carry on the business of coopers; to manufacture and deal in barrels, kegs, packages, drums, and other similar products, whether constructed of wood, metal or other substances, under the name of \"Acme Barrel Manufacturing Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of the par value of S10 each, and 300 preferred shares of the par value of §100.each.The head office of the Company will be at the City of Three Rivers, judicial district of Three Rivers.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.14132-53) Aircraft Welding and Sheet Metals Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of June, 1953, incorporating: Paul Ranger, J.-Jacques Beauchemin, advocates, J.Philippe Beaulac, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate and manage founderies, mills, manufactures for the fabrication of all heavy or, and light pieces of motors, for airplanes, automobiles, engines; to make and install ventilation and hot-air heating systems, under the name of \"Aircraft Welding and Sheet Metals Co.Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 150 preferred shares of a par value of $100 each and into 250 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.13535-63) Alwin Refrigeration & Appliance Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1953, incorporating: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Briskin, advocates, Sybil Schechter, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To buy, manufacture, repair and otherwise deal in radios, television equipment, electrical appliances, fixtures, refrigerating appliances, under the name of \"Alwin Refrigeration & Appliances Co.- Ltd.\", with a capital stock of S60.000, divided into 400 preferred shares of §100 each, and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of June, 1953.L.DÊSILETS.35297-Q Deputy Attorney General.(A.G.14326-53) Arthur Sirois, Ltde Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 2454 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1968, Tome 86, N° 82 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1953, constituant en corporation: Arthur Sirois, garagiste, Gabrielle Côté, ménagère, épouse commune en biens dudit Arthur Sirois, Louis-Philippe Dancause, commis, tous trois de Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Exploiter un ou des garages; faire le commerce d'automobiles, de camions ou autres véhicules-automobiles, sous le nom de \"Arthur Sirois, Ltée\", avec un capital de $100,000, divisé en 600 actions privilégiées de $100 chacune, et en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-o L.DÊSILETS.(P.G.13539-53) Canamerican Helicopter Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept juin 1953, constituant en corporation: Lovell C.Carroll, avocat, de Ville Mont-Royal, Marcel Lajeunesse, Jean-Paul Cardinal, Jacques P.Dansereau, avocats, Thérèse Boissy, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, faire le commerce, exploiter ou autrement utiliser des vaisseaux aériens, aéroplanes, hydroplanes, hélicoptères ou automobiles, sous le nom de \"Canamerican Helicopter Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 40,000, actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.13540-53) Capital Television Installation & Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept juin 1953, constituant en corporation: Ernest Broder, marchand, Thomas Earl Cordell, gérant des ventes, Peter Wouter, technicien, tous des cité et district judiciaire de Montréal et James Norman Green, gérant de service, de la ville de Beaurepaire, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer ou faire le commerce et installer la totalité ou aucune partie de tout outillage et machinerie électrique, de force motrice, de sans-fil, de radio ou de télévision, sous le nom de \"Capital Television Installation & Service Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1953, incorporating: Arthur Sirois, garage-keeper, Gabrielle Côté, housewife, wife common as to property of the said Arthur Sirois, Louis-Philippe Dancause, clerk, all three of Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To operate one or more garages; deal in automobiles, trucks or other motor-vehicles, under the name of \"Arthur Sirois Ltée\", with a capital stock of $100,000 divided into 600 preferred shares of $100 each and into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.13539-53) Canamerican Helicopter Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1953, incorporating: Lovell C.Carroll, advocate, of the Town of Mount-Royal, Marcel Lajeunesse, Jean-Paul Cardinal, Jacques-P.Dansereau, advocates, Thérèse Boissy, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal1, for the following purposes: To manufacture, deal in, operate or otherwise use air ships, aeroplanes, hydroplanes, helicopters or automobiles, under the name of \"Canamerican Helicopter Mfg.Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 40,000 shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1953.L.DÊSILETS.35297-o Deputy Attorney General.(A.G.13540-53) Capital Television Installation & Service Ltd.Notice is hereby given that under Part I oj the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1953, incorporating: Ernest Broder, merchant, Thomas Earl Cordell, sales manager, Peter Wouter, technician, all of the city and judicial district of Montreal, and James Norman Green, service manager, of the Town of Beaurepaire, judicial district of Montréal, for the following purposes: To manufacture or deal in and install the whole or any part of any electrical, automotive, wireless, radio or television equipment, machinery, under the name of \"Capital Television Installation & Service Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.86, No.82 2455 (P.G.14099-53) Capitol (Beauharnois) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux juin 1953, constituant en corporation: Harold S.Freeman, Abrahma H.1.Zaitlin, tous deux avocats, Theresa Murray, secrétaire, fille majeure, de Montréal, Moses S.Yelin, avocat, de Westmount, tous du district judiciaire de Moutréal, pour les objets suivants: Acquérir par achat ou autrement une propriété immobilière consistant principalement en un théâtre de vues animées, sous le nom de \"Capitol (Beauharnois) Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 acttons ordinaires de $30 chacune et 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beauharnois, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.14324-53) Car-Li Creations Cie Limitée Car-Li Creations Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1953, constituant en corporation: Albert Montpetit, manufacturier, André Mont-grain, comptable agréé, Giselle Delorme, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchandises sèches, sous le nom de \"Car-li Creations Cie Limitée\" \u2014\"Car-Li Creations Co.Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions communes de $100 chacune, et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-o L.DÊSILETS.(P.G.14133-53) t Chamberland Service Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois juin 1953, constituant en corporation : Alfred Chamberland, garagiste, Yolande Roy, sténographe, André Trottier, comptable agréé, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire le commerce général de gazolines, huiles, lubrifiants, automobiles, ainsi que la réparation et l'entretien de véhicules moteurs de tout genre, sous le nom de \"Chamberland Service Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 1,000 actions de $40 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.(A.G.14099-53) Capitol (Beauharnois) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, 1953, incorporating: Harold S.Freeman, Abraham H.J.Zaitlin, both advocates, Theresa Murray, secretary, spinster, of Montreal, Moses S.Yelin, advocate, of West-mount all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire, by purchase of otherwise, an im- ' moveable property, consisting principally of a moving picture theatre, under the name of \"Capitol (Beauharnois) Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of $50.each and 600 preferred shares of the par value of $50.each.The head office of the Company will be at Beauharnois, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-0 Deputy Attorney General.(A.G.14324-53) Car-Li Creations Cie Limitée Car-Li Creations Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1953, incorporating: Albert Montpetit, manufacturer, André Montgrain, chartered accountant, Giselle Delorme, secretary spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in drygoods, under the name of \"Car-Li Creations Cie Limitée\" \u2014 \"Car-Li Creations Co.Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 300 common shares of $100 each, and into 100 preferred shares of $100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.14133-53) Chamberland Service Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of June 1953, incorporating: Alfred Chamberland, garage-keeper, Yolande Roy, stenographer, André Trottier, chartered accountant, all of Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: To deal in generally: gasoline, oils, lubricants, automobiles, as well as in the repairing and maintenance of motor vehicles of all kinds, under the name of \"Chamberland Service Limitée\", with a capital stock of $40,000, divided into 1,000 shares of $40 each.The head office of the company shall be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third day of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General. 2456 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 82 (P.G.14328-53) Cima Department Store Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six juin 1953, constituant en corporation: Philip Meyerovitch, avocat et conseil en loi de la Reine, Morris Shuter, gérant de bureau , de Montréal, Louis Feigenbaum, avocat, de Ville Saint-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de cotonnades, textiles, vêtements, fournitures de maison, nouveautés et chaussures, sous le nom de \"Cima Department Store Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 10 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,990 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.14305-53) Clearwater Exploration Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-trois juin 1953, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, de St-Lambert, William Patrick Crcagli, commis en loi, de Ville Mont-Royal, Alexander Gordon Yeoman, commis en loi, de Montréal, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces, industries et activités qui consistent â prospecter, explorer, gérer et exploiter des mines, des gisements pétrolifères, et gazeux, du bois, des exploitions forestières et le développement des ressources naturelles, sous le nom de \"Clearwater Exploration Limited\", avec un capital de $10,000 divisé en 10,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.14247-53) ; Don-O-Lite Manufacturing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1953, constituant en corporation: Dominic Vincent Ortenzi, contremaître, Natale Ortenzi, rentier, et Emilienne Bourgeois, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre, négocier comme grossistes ou détaillants des lampes, des abat-jour, ainsi que tout autre article ou objet mobilier, en métal, bois, plastiques ou autres matières ouvrables, sous le nom de \"Don-O-Lite Manufacturing Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.(A.G.14238-53) Cima Department Store Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1953, incorporating: Philip Meyerovitch, advocate and Queen's Counsel, Morris Slmtcr, office manager, of Montréal, Louis Feigenbaum, advocate, of Ville Saint-Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturer and dealer in cottons, textiles, clothing, house furnishings, novelties, shoes, under the name of \"Cima Department Store Ltd.\", with a capital stock of 810,000, divided into 10 common shares of the par value of SlO each, and 3,990 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.14305-53) Clearwater Exploration Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of June, 1953, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, of St.Lambert, William Patrick Crcagh, law clerk, of the Town of Mount Royal, Alexander Gordon Yeoman, law clerk, of Montreal, Charles Eric Humphrey, Guy Ambrose Miller, bookkeepers, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business, trades and activities of prospecting for, exploring, managing and operating, mining, oil, gas, timber, logging and natural ressources, under the name of \"Clearwater Exploration Limited\", with a capital stock of $10,000.divided into 10,000 shares of $1.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.14247-53) Don-O-Lite Manufacturing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1953, incorporating: Dominic Vincent Ortenzi, foreman, Natale Ortenzi, annuitant, and Emilienne Bourgeois, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To buy, sell, negociate as wholesalers or retailers in lamps, shades, as well as any other article or object or furniture in metal, wood, plastic or other workable matters, under the name of \"Don-O-Lite Manufacturing Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.85, No.82 2457 Le siège social de la compagnie sera à 2025, The head office of the company will he at rue Albert, chambre 300, Montréal, district ju- 2025 Albert Street, Room 300, Montreal, judi- ciaire de Montréal.Daté (lu bureau du Procureur général le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-o L.DÊSILETS.(P.C.11972-53) Écho des Laiirentides Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept juin 1953, constituant en corporation: Marcel Frenette, comptable licencié, Femand Ladouccur, agent, Roger Lorlie, comptable, René Ladouccur, journaliste, tous quatre de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, et Marcel God in, agent, de Saint-Adolphe «l'Howard, tous du district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce de propriétaire, éditeur de journaux et imprimeur et publiciste, sous le nom de \"Écho des Laurcntides Ltée\", avecun capital de $5,000, divisé en 500 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saintc-Agathc-dcs-Monts, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.(P.G.10157-53) Empire Finance Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1953, constituant en corporation: Paul Weil Brenner, courtier, Jacques Weil Brenner, entrepreneur, J.-Anatole Weil Brenner, courtier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Prêter de l'argent, sous le nom de \"Empire Finance Corporation\", avec un capital de $225,000, divisé en 1,250 actions privilégiées de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social dp la compagnie sera au numéro 3929, rue Saint-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf juin 1953.L'Assistant-procureur général.35297-0 L.DÊSILETS.cial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day «>f June.1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.11972-53) Echo des Lauren I ides Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June.1953, incorporating: Marcel Frenet-te, chartered accountant, Fern and Ladouccur.agent.Boner Lortie, accountant.Bene Ladouccur journalist, all four of the town of Stc-Agathc-dcs-Monts, and Marcel Godin, agent, of Saint-Adolphe d'Howard, all of the judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To act as proprietor and be a newspaper editor, printer and publicist, under the name of \"Écho des Laurcntides Ltée\", with a capital stock of $5,000, divided into 500 shares of S10 each.The head office of the company will be at Sainte-Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.10157-53) Empire Finance Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June 1953, incorporating: Paul Weil Brenner, broker.Jacques Weil Brenner, contractor, J.-Anatole Weil Brenner, broker, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To lend money, under the name of \"Empire Finance Corporation\", with a capital stock of $225,000, divided into 1,250 preferred shares of $100 each and 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company shall be at number 3929, St.Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the nineteenth day of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(P.G.1429S-53) Ltd.Grenier & Dubois Construction j t(/ Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1953, constituant en corporation: H.-Rolland Dubois, constructeur, Olivette Dubois, secrétaire, épouse dut it H.-RoHnnd Dubois, tous deux de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, Fernand Grenier, constructeur, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux pour la construction et l'exécution de travaux privés et (A.G.14298-53) Grenier & Dubois Construction Ltd.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieulcnant-Governlr of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June 1953, incorporating: IL Rolland Dubois, builder.Olivette Dubois, secretary, wife of said H.Rolland Dubois, both of Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis, Fcmaud Grenier, builder, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate as general contractors for the construction and execution of private and public 2458 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 86, N° 82 publics, sous le nom de \"Grenier & Dubois Construction Ltd.Ltée\", avec un capital de §40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-o L.DÊSILETS.(P.G.13530-53) Glamour Garment Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq juin 1953, constituant en corporation: Willie Berger, Ernest Goldstein, tous deux manufacturiers, Raymonde Doyle, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et vendre ou autrement faire le négoce ou le commerce de laine, tissus de coton, lainages, soieries, toiles et vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Glamour Garment Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÉSDLETS.(P.G.9045-53) Harleigh (Canada) Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf juin 1953, constituant en corporation: Manuel Gitnick, manufacturier, Shirley Steinberg Gitnick, marchande publique, épouse séparée de biens dudit Manuel Gitnick, Theodore Gitnick, gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements et habits de toutes sortes ainsi que des vêtements de sport, sous le nom de \"Harleigh (Canada) Co.Inc.\", avec un capital de $30,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.13532-53) Hillsdale Golf and Country Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du dix-huit juin 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Saul Tarnofsky, administrateur, de Hampstead, Philip Berman, Abe Pins-ky, administrateurs, Cecil Vineberg, comptable agréé, Louis Shoore, Joshua Uditsky, agents d'immeubles, Lionel Goodman, inprimeur, Irving Wenger, marchand, Manuel Shacter, avo- works under the name of \"Grenier & Dubois Construction Ltd.Ltée\", with a capital stock of S40.000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A G.13530-53) Glamour Garment Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1953, incorporating: Willie Berger, Ernest Goldstein, both manufacturers, Raymonde Doyle, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the jollowing purposes: To manufacture and sell or otherwise deal in or with wool, cotton fabrics, woollens, silks, linens and clothing of every sort, under the name of \"Glamour Garment Mfg.Co.Ltd.\", with a capital stock of S40.000 divided into 300 preferred shares having a par value of S100.each, and 100 common shares having a par value of $100.each./\u2022 The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.9045-53) Harleigh (Canada) Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1953, incorporating: Manuel Gitnick, manufacturer, Shirley Steinberg Git-nick, marchande publique, wife separate as to property of the said Manuel Gitnick, Theodore Gitnick, manager, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, and clothing of all kinds, as well as sportwear, under the name of \"Harleigh (Canada) Co.Inc.\", with a capital stock of $30,000.divided into 100 common shares of a par value of $100.each, and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.13532-53) Hillsdale Golf and Country Club Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governorof the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1953, incorporating as a corporation without share capital: Saul Tamofsky, executive, of Hampstead, Philip Berman, Abe Pinsky, executives, Cecil Vineberg, Chartered accountant, Louis Shoore, Joshua Uditsky, real estate agents, Lionel Goodman, printer, Irving Wenger, merchant, Manuel Shacter, advocate, of Montreal, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.85, No.82 2459 cat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir, exploiter et administrer un club de golf et champêtre au bénéfice et à l'avantage de ses membres et leurs invités, sous le nom de \"Hillsdale Golf and Country Club Inc.\" Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $500,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.13327-53) Imperial Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-huit juin 1953, constituant en corporation: Raymond Lebceuf, avocat, Gisèle Behocaray, fille majeure, secrétaire, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, Myrto Brasseur, secrétaire, fille majeure, de Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands d'obligations, courtiers de placements et d'actions dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Imperial Investments Inc.\", avec un capital de 810,000, divisé en 10,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district jijdiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.13331-53) Lajeunesse Automobile Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- ~ vince de Québec, des lettres patentes, en date du quinze juin 1953, constituant en corporation: Jacques Boisclair, marchand, Lucie Béland-Boisclair, ménagère, Robert Dufresne, comptable, tous trois des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules-automobiles, motocyclettes, bicycles, moteurs; et exploiter des garages, sous le nom de \"Lajeunesse Automobile Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 350 actions privilégiées de $100 chacune et en 50 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9561, rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1953.L'Assistant-procureur général.35297-0 L.DÊSILETS.(P.G.13537-53) Lakes bore Hotel Inc.all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote, operate and manage a golf and country club for the benefits and advantages of its members and their guests, under the name of \"Hillsdale Golf and Country Club Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $500,000.The head office of the Corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 40297-o Deputy Attorney General.(A.G.13327-53) Imperial Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, representee! by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighteenth day of June, 1953, incorporating: Raymond Lebceuf, advocate, Gisèle Behocaray, spinster, secretary, both of the city and judicial district of Montreal, Myrto Brasseur, secretary, spinster, of St.Eustache, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of bond dealers, investment and share brokers in all its branches, under the name of \"Imperial Investments Inc.\", with a capital stock of 810,000, divided into 10,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.13331-53) Lajeunesse Automobile Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June 1953, incorporating: Jacques Boisclair, merchant, Lucie Béland-Boisclair, housewife, Robert Dufresne, accountant, all three of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in motor vehicles, motorcycles, bicycles, motors; and operate garages, under the name of \"Lajeunesse Automobile Limitée\", with a capital stock of $40,000, divided into 350 preferred shares of $100 each and 50 common shares of $100 each.The head office of the company shall be at 9561, Lajeunesse Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fifteenth dav of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.13537-53) Lakeshore Hotel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, des lettres patentes, en date du Province of Quebec, bearing date the seventeenth dix-sept juin 1953, constituant en corporation: day of June 1953, incorporating : Lucien Thouin, 2400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1958, Tome S5, N° 82 advocate, Jacqueline Matte, Paula Boisvert, stenographers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate hotels, restaurants, tourist houses, under the name of \"Lakcshore Hotel Inc.\", with a capital stock of §100,000, divided into 820 preferred shares of S100 each and 1,800 common shares of a par value of S10 each.The head office of the company shall be at Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the seventeenth day of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.14458-53) Les Duplets'Tremblay Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating without share capital: Paul-Emile Tremblay, laborer, Jos.A.Bergeron, physician, both of the town of Saint-Joseph d'AIma, judicial district of Iloberval, and Paul-Emile Lavoic.manager, of Saint-Amhroi.se, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To assure the moral and material welfare of the family of Paul-Emile Tremblay, under the name of \"Les Duplets Tremblay Inc.\".The amount to which the immoveable property which the corporation may hold is limited, is 8300,000.The head office of the corporation will, beat Saint-Joseph d'AIma, judicial district of Iloberval.\\ Dated at the office of the Attorney General, this third day of July, 1953.L.DÊSILETS, 35297 / Deputy Attorney General.(A.G.12577-53) Les Entreprises Yvon L'Heureux Limitée Yvon L'Heureux Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June 1953, incorporating: Yvon L'Heureux, merchant, Jean-Noël Miville, accountant, of Beloeil Station, judicial district of Richelieu, Mariette Rcnouf, accountant, of Verdun, judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in materials of construction, hardware, under the name of \"Les Enterprises Yvon L'Heureux Limitée\" \u2014 \"Yvon L'Heureux Enterprises Limited\", with a capital of 8100,000 divided into 900 preferred shares of a par value of 8100 each and 2,000 common shares of a par value of 85 each.The head office of the company shall be at Beloeil Station, judicial district, of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-second day of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(P.G.13386-53) m (A.G.13386-53) Manny Realty Inc.Manny Realty Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the Lucien Thouin, avocat, Jacqueline Matte, Paula Boisvert, sténographes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, restaurants, maisons de touristes, sous le nom de \"Lakcshore Hotel Inc.\", avec un capital de $100,000, divisé en 820 actions privilégiées de 8100 chacune et en 1,800 actions ordinaires d'une valeur au pair «le 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général le dix-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-o L.DÊSILETS.(P.G.14458-53) Les Duplets Tremblay Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions «le la troisième partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu trois juillet 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Paul-Emile Tremblay, journalier, Jos-A.Bergeron, médecin, tous deux «le la ville «le Saint-Joseph «l'Aima, district judiciaire «le Roberval, et Paul-Émilc Lavoie, gérant, de Saint-Ambroise, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Assurer le bien-être matériel et moral de la famille de Paul-Émilc Tremblay, sous le nom de \"Les Duplets Tremblay Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8300,000.Le siège social «le la corporation sera à Saint-Joseph «l'Aima, district judiciaire «le Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-c L.DÊSILETS.(P.G.12577-53) Les Entreprises Yvon L'Heureux Limitée Yvon L'Heureux Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la-province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1953, constituant en corporation: Yvon l'Heureux, commerçant, Jean-Noël Miville, comptable, de Beloeil Station, district judiciaire de Richelieu, Mariette Rcnouf, comptable, de Verdun, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction, de quincaillerie, sous le nom de \"Les Entreprises Yvon l'Heureux Limitée\" \u2014 Yvon L'Heureux Enterprises Limited\", avec un capital de 8100,000 divisé en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et de 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 85.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beloeil Station, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux juin'1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1953, Vol 85, No.32 2461 province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf juin 1953, constituant en corporation: Max Silver, manufacturier, Mollie Davis, épouse séparée de biens de Max Silver, Harry Rabinovitch, gérant de manufacture, tous éù la cité de Montréal, et Claire Rabinovitch, veuve de feu Issie Manny Finkelstein, de la cité d'Ou-tremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et administrer certaines propriétés immobilières, sous le nom de \"Manny Realty Inc.\", avec un capital de S140.000 divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune et .1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, de vingt-neuf juin 1953.L'Assistant-prolureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.14297-53) Mercantile Warehousing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six juin 1953, constituant en corporation : Nathan Levitsky, avocat, Rose Markis, secrétaire, fille majeure, Solomon Weber, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des entrepôts et des établissements d'entreposage frigorifique, sous le nom de \"Mercantile Warehousing Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six juin 1953.L'Assistant-procureur général.35297 L.DÉSDLETS.(P.G.13372-53) Mercury Finance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1953, constituant en corporation: Emile Maheu, Aurélien Noël, Rodolphe Maheu d'Outremont, Bernard Robert, Marcel Hurtu-bise, de Montréal, Antoine-R.Faggiolo, de Saint-Lambert, tous comptables agréés, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de prêteur d'argent, sous le nom de \"Mercury Finance Inc.\", avec un capital de $225,000, divisé en 17500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général.35297-0 L.DÊSILETS.(P.G.13568-53) Montreal-Granby Press Inc.Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1953, incorporating: Max Silver, manufacturer, Mollie Davis, wife separate as to property of Max Silver, Harry Rabinovitch.Factory Manager, all of the City of Montreal, and Claire Rabinovitch, widow of the late Issie Manny Finkelstein, of the 'city of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and manage certain immoveable properties, under the name of \"Manny Realty Inc.\", with a capital stock of S140.000.divided into 400 common shares of $100.each, and 1,000 preferred shares of S100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.14297-53) Mercantile Warehousing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1953, incorporating: Nathan Levitsky, advocate, Rose Markis, secretary, spinster, Solomon Weber, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate warehouses and cold storage plants, under the name of \"Mercantile Ware-, housing Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.13372-53) Mercury Finance Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June 1953, incorporating: J.-Émile Maheu, Aurélien Noël, Rodolphe Maheu, of Outremont, Bernard Robert, Marcel Hurtubise, of Montreal, Antoine-R.Faggiolo, of Saint-Lambert, all chartered accountants, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the general business of money lenders, under the name of \"Mercury Finance Inc.\", with a capital stock of $225,000, divided into 17500 preferred shares of a par value of $10 each and 5,000 common shares of a par value of $10.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh day of June 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.13568-53) Montrcal-Grànby Press Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the sixteenth 2462 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 82 du seize juin 1953, constituant en corporation: Jacques Francceur, Robert Allard, tous deux éditeurs, Roland-A.Diamond, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs, de libraires, d'impressions photographiques, sous le nom de \"Montreal-Granby Press Inc.\", avec un capital de 850,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le seize juin 1953.L'Assistant-))rocureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.(P.G.14250-53) New Tex Hosiery Mfg.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la drovince de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq juin 1953, constituant en corporation: Joseph J.Shapiro, Morton Margolian, marchands, Sureka Wasserman, secrétaire,- fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et vendre des bas en soie et en nylon pour dames, sous le nom de \"New Tex Hosiery Mfg.Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général,.35297-0 L.DÉSIXETS.(P.G.14251-53) Notre Dame Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq juin 1953, constituant en corporation: Kenneth Albert Wilson, John McGlinchey Home, avocat, et conseils en loi de la Reine, Kenneth Hunter Wilson, avocat, Helen Hague, gérante de bureau, fille majeure, Enid Mary Roberts, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et agents d'immeubles, sous le nom de \"Notre-Dame Realties Ltd.\", avec un capital de $25,000, divisé en 2.500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÉSIXETS.(P.G.12851-53) Service des Loisirs de Notre-Dame-dcs-Victoires Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vngt-deux juin 1953, day of June 1953, incorporating: Jacques Francceur, Robert Allard, both editors, Roland-A.Diamond, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of printers, booksellers, and deal in photographic prints, under the name of \"Montreal-Granby-Press Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 1,000 common shares of a par value of $10.each, and 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company shall be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the sixteenth day of June 1953.L.DÉSIXETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.14250-53) New Tex Hosiery Mfg.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1953, incorporating: Joseph J.Shapiro, Morton Margolian, merchants, Sureka Wasserman, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and sell ladies silk and nylon stockings, under the name of \"New Tex Hosiery Mfg.Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100.each, and 200 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.14251-53) Notre Dame Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1953, incorporating: Kenneth Albert Wilson, John McGlinchey Home, advocates and Queen's Counsel, Kenneth Hunter Wilson, advocate, Helen Hague, office manager, spinster, Enid Mary Roberts, stenographer, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate dealers and agents, under the name of \"Notre Dame Realties Ltd.\", with a capital stock of $25,000, divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of June, 1953.L.DÉSIXETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.12851-53) Service des Loisirs de Notre-Dame-des-Victoires Notice is hereby given that under the provisions of Part m of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1953, Vol.85, No.82 2463 constituant en corporation sans capital-actions : Henri Brassard, comptable, Victoire Lévesque, célibataire majeure, couturière, et Laurent Ouimet, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Développer les loisirs dans la paroisse de Notre-Dame-des-Victoires, de Montréal, sous le nom de \"Service des Loisirs de Notre-Dame-des-Victoires\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $1,000,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 ' L.DÊSILETS' (P.G.14236-53) Quebec Adjustement Company La Compagnie d'Ajustement de Québec Avis est donné qu-'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gauverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juin 1953, constituant en corporation: Louis BaUlargeon, Jules Baillargeon, notaires, Rita Saint-Hilaire, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer généralement les commerce et opération d'enquêteur, d'ajusteur et évaluateur, sous le nom de \"Quebec Adjustment Company\" \u2014 \"La Compagnie d'Ajustement de Québec\", Le montant du capital-actions de la compagnie sera divisé en 300 actions ordinaires sans valeur au pair et en 90 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.' Daté du bureau du Procureur général le vingt-six juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.(P.G.13538-53) Super Auto Services Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-sept juin 1953, constituant en corporation: Nathan Levitsky, avocat, Rose Markis, secrétaire fille majeure, Solomon Weber, avocat, conseil en loi de la Reine, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre un commerce général de garage, de pièces d'automobiles et faire le lavage d'autos, sous le nom de \"Super Auto Services Ltd.\", avec un capital de $200,000 divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 7,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.13541-53) Taylor Duplicating & Mailing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a 1953, incorporating without share capital: Henri Brassard, accountant, Victoire Lévesque, spinster, seamstress and Laurent Ouimet, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To develop recreational centers in the parish of Notre-Dame-des-Victoires, of Montreal, under the name of \"Service des Loisirs de Notre-Dame-des-Victoires\".The amount to which the immoveable property which the corporation mav hold is limited, is $1,000,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.14236-53) Quebec Adjustement Company La Compagnie d'Ajustement de Québec Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of June, 1953, incorporating: Louis Bairllargeon, Jules Baillargeon, notaires, Rita Saint-Hilaire, secretary, all of the city aud judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on, generally, the business and operations of an investigator, an adjuster and ap-raiser, under the name of Quebec Adjustment Company\" \u2014 \"La Compagnie d'Adjustement de Québec\".The amount of the capital stock of the company will be divided into 300 common shares of no par value and into 90 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Québec.Dated at the office of the Attorney General this twenty-sixth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.(A.G.13538-53) Super Auto Services Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1953, incorporating: Nathan Levitsky, advocate, Rose Markis, secretary, and fille majeure, Solomon Weber, advocate, Queen's Counsel, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in a general garage, auto-parts and car-wash business, under the name of \"Super-Auto Services Ltd.\", with a capital stock of $200,000.divided into 5,000 common shares of a par value of $10.each and 7,500 preferred shares of a par value of $20.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-0 Deputy Attorney General.(A.G.13541-53) Taylor Duplicating & Mailing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 2464 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1953, Tome 85, N° 82 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-septième jour de juin, 1953, constituant en corporation: M oses Samuel Yelin, avooat, Lillian Winch.Esther Monson, secretaires,tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un service de polycopie et postal, sous le nom de \"Taylor Duplicating & Mailing Inc.\", avec un capital de 840,000 divisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair de S100 chacune, et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur-général, ce vingt-septième jour de juin, 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÊSILETS.(P.G.13385-53) The Trainatoriura Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, des lettres patentes, en date du vingt-neuf juin, 1953, constituant en corporation: Louis Lasanik, marchand, Ida Lazanik, ménagère, épouse séparée de biens de Louis Lazanik, Nathan Lazanik, vendeur, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants; Exercer le commerce de manufacturiers, marchands, et négociants de jouets, nouveautés, des trains électriques, des passe-temps, des étalages, de l'annonce en général et toutes fournitures, sous le nom de \"The Trainatorium Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf juin, 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÉSIXETS.(P.G.12834-53) Trans-Canada Movers and Storage Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour de juin, 1953, constituant en corporation: Barney Vinegar, Lewis Vinegar, maîtres-charretiers, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, Edward Robert Fowler, comptable agréé, de la cité de Moncton, province du Nouveau Brunswick, pour les objets suivants: Exercer le commerce de camionnage et de transport d'effets, objets, marchandises, sous le nom de \"Trans-Canada Movers and Storage Ltd.\", avec un capital de $30,000, divisé en 150 actions ordinaires de 8100 chacune et en 150 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2110 rue Sainte-Catherine ouest, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour de juin, 1953.L'Assistant-procureur général, 35297 L.DÉSIXETS.(P.G.12589-53) Wolfe Bros.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1953, incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Lillian Winch, Esther Monson, secretaries, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a duplicating and mailing service, under the name of \"Taylor Duplicating & Mailing Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 100 common shares of the par value of $100.each, and 300 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-seventh day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-o Deputy Attorney General.(A.G.13385-53) The Trainatorium Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1953, incorporating: Louis Lazanik, storekeeper, Ida Lazanik, housewife, wife separate as to property of Louis Lazanik, Nathan Lazanik, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in and with toys, novelties, toy electric trains, hobbies, displays, general advertising and all supplies, under the name of \"The Trainatorium Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1953.L.DÊSILETS.35297-Q Deputy Attorney General.(A.G.12834-53) Trans-Canada Movers and Storage Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1953, incorporating: Barney Vinegar, Lewis Vinegar, master carters, both of the city and judicial district of Montreal, Edward Robert Fowler, chartered accountant, of the city of Moncton, province of New Brunswick for the following purposes: To carry on the business of trucking and transporting goods, wares and merchandises, under the name of \"Trans-Canada Movers and Storage Ltd.\", with a capital stock of $30,000, divided into 150 common shares of $100 each, and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 2110 St.Catherine St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1953.L.DÊSILETS, 35297-0 Deputy Attorney General.(A.G.12589-53) Wolfe Bros.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1968, Vol.86, No.32 2465 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt juin, 1953, constituant en corporation: Joseph Wolfe, Louis Wolfe, Harry Wolfe, marchands, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le métier et le commerce de marchands de marchandises sèches, marchandises en pièces, et toutes sortes de vêtements et d'articles vestimentaires, sous le nom de \"Wolfe Bros.Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de-Montréal.Daté du bureau du Procureur général ce vingtième jour de juin, 1953.L'Assistant-procureur général, 36297 L.DÊSILETS.Lettres patentes supplémentaires (P.G.14244-53) AVIS DE CORRECTION Re Fédération des Œuvres de Charité Canadienne-Françaises, Inc.Avis est donné (pic l'avis publié dans la Gazette officielle de Québec, tome 85, N° 31, du 1er août 1953, à la page 2437, sous le titre \"Lettres.Patentes\", concernant la corporation ci-haut mentionnée, est corrigé de la façon suivante: dans la quatrième ligne de la version française dudit avis, au lieu des mots \"des lettres patentes\", il faut lire: \"des lettres patentes supplémentaires\", et dans la deuxième ligne de la version anglaise, au lieu des mots \"letters patent\", il faut lire: \"supplementary letters patent\".En conséquence, le titre lui-même de l'avis doit aussi être corrigé pour se lire, en français, \"Lettres Patentes Supplémentaires\", et, en anglais, \"Supplemeutary Letters Patent\".Daté du bureau du Procureur général le 3 août 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.Arrêtes en Conseils been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June, 1953, incorporating: Joseph Wolfe, Louis Wolfe, Harry Wolfe, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of dealers in dry goods, piece goods, and all kinds of clothing and wearing apparel, under the name of \"Wolfe Bros.Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 100 common shares of $100.each, and 300 preferred shares of SI00.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office^ of the Attorney General this twentieth day of June.1953.L.DÊSILETS, 36297-0 Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent (A.G.14244-53) NOTICE OF CORRECTION Re Fédération des Œuvres de Charité Canadienne-Françaises, Inc.Notice is given that the notice, published in the Quebec Official Gazette, Vol.85, No.31, of August 1st, 1953, on page 2437, under the title \"Letters Patent\", concerning the above mentione corporation, is corrected in the following way: in the fourth line of the French version of the said notice, instead of the words \"des lettres patentes\", please reae: \"des lettres patentes supplémentaires\" and, in the second line of the English version, instead of the words \"letters patent\", please read: \"supplementary letters patent\".Therefore, the title of the notice itself should also be corrected to read, in French, \"Lettres Patentes Supplémentaires\", and, in English, \"Supplementary Letters Patent\".Dated at the office of the Attorney General, August 3, 1953.L.DÊSILETS, 46297 Deputy Attorney General.Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ' Numéro 886 Québec, le 30 juillet 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Section \"G\" Concernant des modifications au décret relatif au commerce de quincaillerie, ferronnerie et peinture dans les cités de Québec et Lévis et la ville de Lauzon.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de quincaillerie, ferronnerie et peinture dans les cités de Québec et Lévis et la ville de Lauzon, ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBTR Number 886 Quebec, July 30, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part\"G\" Concerning amendments of the decree relating to the hardware and paint trade in the cities of Quebec and Levis and the town of Lauzon.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the hardware and paint trade in the cities of Quebec and Levis and the town of Lauzon, rendered obligatory by the 2466 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 8 août 1953, Tome 86, N° 32 rendue\"obligatoire par le décret numéro 1090 du 7 mars 1940, amendé par les arrêtés numéros 4200 et 4252 des 28 novembre et 1er décembre 1910, 1043 du 30 avril 1941, 1168, 1756 et 3144 des 13 mai, 24 juillet et 20 novembre 1942, 2631 du 10 septembre 1943, 1431 du 28 avril 1944, 3499 du 1er septembre 1945, 1655 et 4717 des 10 mai et 14 novembre 1946, 1310-B du 12 août 1947, 68-13, 1162-A et 1763-B des 22 janvier, 9 septembre et 23 décembre 1948, 1029-A et 1198-C des 14 septembre et 27 octobre 1949, 915-A du 9 août 1950, 735-C du 12 juillet 1951, 1396-B du 13 décembre 1951 et 556-B du 14 mai, 1952, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 13 juin 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications porposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que ledit décret, numéro 1090, soit modifié comme suit: 1° Le deuxième alinéa du paragraphe \"j\" de l'article II est remplacé par le suivant: Toutefois, après une année de service comme messager, le salarié doit être classifié dans une des catégories de commis mentionnées au décret, et l'année de travail comme messager ne doit pas être comptée comme année d'expérience comme commis dans la catégorie dans laquelle le salarié est classifié.2° Le paragraphe \"k\" de l'article II est remplacé par le suivant: k) Le tenue \"employé junior\" désigne tout salarié exécutant le travail ordinairement reconnu sous le nom d'ouvrage général, garçon de magasin, garçon d'ascenseur; toutefois, après une aimée de travail dans cette classification le salarié doit être classifié dans une des catégories de commis décrites au décret et l'année de travail comme employé junior ne doit pas être comptée comme année d'expérience dans la catégorie de commis dans laquelle le salarié est classifié.3° Le dernier alinéa du paragraphe \"6\" de l'article III est remplacé par le suivant: En dehors des heures mentionnées ci-haut, un salarié ne peut travailler et un employeur ou un employeur professionnel ne peut faire travailler un salarié à la vente dans un établissement régi par le présent décret.4° A l'article IV, les taux de salaires minima mentionnés pour la classification d'emploi ci-après énumérées, sont remplacés par les suivants: par semaine \"a) 1.Gérant.$63.00 2.Chef-comptable.56.50 3.1er commis à la vente.56.50 4.1er commis réception et expédition____.53.00 5.1er commis aux commandes.53.00 b) Livreur.45.50 c) Aide-livreur\u2014moins 21 ans.29.00 Aide livreui\u2014 21 ans et plus.33.50 d) Messager.-.15.00 f) Personnel masculin de bureau: 1ère année.21.50 2ème année.25.50 3ème année.28.50 4ème année.33.00 5ème année.38.50 6ème année.42.50 7ème année.46.00 decree number 1090 of March 7, 1940, and amended by Orders 4200 and 4252 of November 28 and December 1, 1940, 1043 of April 30, 1941.1168, 1756 and 3144 of May 13, July 24 and November 20, 1942, 2631 of September 10, 1943, 1431 of April 28,1944, 3499 of September 1,1945, 1655 and 4717 of May 10 and November 14, 1946, 1310-B of August 12, 1947, 68-B, 1162-A and 1763-B of January 22, September 9 and December 23, 1948, 1029-A and 1198-C of September 14 and October 27, 1949, 915-A of August 9, 1950, 735-C of July 12, 1951, 1396-B of December 13, 1951, and 556-B of May 14, 1952, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree; Whereas the said petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of June 13, 1953; Whereas no objection was made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore on the recommen dation of the Honourable Primé Minister.That the said decree, number 1090, be amen ded as follows: 1.The second paragraph of subsection \"j\" of section II is replaced by the following: However, after one year of service as messenger, the employee shall be classified in one of the clerk categories mentioned in the decree and that year of work as messenger shall not be considered as a year of experience as clerk in the category in which the employee is classified.2.Subsection \"k\" of section H is replaced by the following: k) The words \"junior employee\" mean any employee doing the work ordinarily called \"general work,\" or that of store or elevator boy; however, after one year of work in this classification, the employee shall be classified in one of the clerk categories described in the decree and that year of work as junior employee shall not be considered as a year of experience in the clerk category in which the employee is classified.3.The last paragraph of subsection \"b\" of section HI is feplaced by the following: Outside the hours mentioned above, no employee shall work and no employer or professional employer shall cause sales work to be done by an employee in an establishment governed by the present decree.4.The minimum wage rates for the following classifications of employment, as mentioned in section TV, are replaced by the following: per week \"a) 1.Manager.$63.00 2.Chief-accountant.56.50 3.Head sales-clerk.56.50 4.Head receiving and shipping clerk.53.00 5.Head order clerk.53.00 b) Delivery-man:.45.50 c) Delivery-man's helper: under 21 years of age.29.00 21 years of age and over.33.50 d) Messenger.15.00 f) Male office clerk: \u2022 1st year.21.50 2nd year.25.50 3rd year.28.50 4th year.33.00 5th year.38.50 6th year.42.50 7th year.46.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.85, No.32 2467 8ème année.49.50 9ème année.53.00 g) Commis à la vente: 1ère année.20.00 2ème année.23.50 3ème année.28.50 4ème année.32.00 Sème année.37.00 6ème année.41.50 7ème année.43.50 Sème année.48.50 9ème année.53.00 h) Commis à réception et expédition: 1ère année.21.50 2ème année.25.50 3ème aimée._.28.50 4ème année.33.00 5ème année.36.00 6ème année.39.00 7èine aimée.40.00 8èmc année.43.00 9ème année.45.50 i) Commis aux commandes: 1ère année.21.50 2ème année.25.55 3ème année.20.50 4ème année.33.00 Sème année.36.00 6ème année.39.00 7ème année.41.50 8ème année.45.50 9èmc année.48.50 l'heure k) Commis supplémentaire.0.90 /) Commis surnuméraire.0.60 m) Personnel féminin de bureau: par semaine 1ère année.20.00 2ème année.;.24.50 3ème année.29.50 4ème année.33.00 mm) Autre personnel féminin: 1ère année.19.00 2ème année.22.50 3ème année.27.00 4ème année.29.50 n) 1.Ouvrier de métier qualifié- 51.50 2.Ouvrier de métier non qualifié.44.00 o) Apprenti de métier l'heure lèr,e année.45 2ème année.56 3ème année.68 4ème année.80 p6 Employé d'ouvrage général: Employé senior: par semain moins de 25 ans.42.00 25 ans et plus.45.50 b) Employé junior.19.00 «7) Gardien de nuit.39.00\" 66 Les taux de salaires pour chacune des classifications d'emploi mentionnées au paragraphe 7 de l'article VI-B sont remplacés par les suivants: Occupation: par semaine ,(a) 1.Gérant.$63.00 2.Chef-comptable.56.00 3.Premier commis à la vente.66.09 4.Premier commis d'entrepôt : 1ère année.45.00 2ème année.49.50 b) Livreur.45.00 c) Aide-livreur: moins de 21 ans.28.00 21 ans et plus.34.50 d) Personnel masculin de bureau: 1ère année.20.50 2ème année.25.00 3ème année.28 50 8thyear.49.50 9thyear.53.00 g) Sales clerk: 1st year.20.00 2nd year.23.50 3rd year.28.50 4th year.32.00 5th year.37.00 6th year.41.50 7th year.43.50 8th year.48.50 9th year.53.00 h) Receiving and shipping clerk: 1st year.21.50 2nd year.25.50 3rd year.28.50 4th year.33.00 5th year.36.00 6th year.39.00 7th year.40.00 8th year.43.00 9th year.45.50 i) Orders clerk: 1st year.21.50 2nd year.25.50 3rd year.28.50 4th year.33.00 5th year.36.00 ' 6th year.39.00 7th year.41.50 8th year.45.50 9th year.:.48.50 per hour k) Extra clerk.0.90 I) Supcrnumery clerk.0.60 m) Female office clerk: per week 1st year.20.00 2nd year.24.50 3rd year.'.29.50 4th year.33.00 mm) Other female employees: 1st year.19.00 2nd year.22.50 3rdvear.27.00 4th year.29.50 n) 1.Skilled tradesman.51.50 2.Unskilled tradesman.44.00 0) Trade apprentices: per hour 1st year.0.45 2nd year.0.56 3rdvear.0.68 4th year.0.80 p) General hand: a) Senior employee: per week Under 25 years of age.42.00 25 years of age and over.45.50 b) Junior employee.19.00 q) Night watchman.39.00\" 5.The wages rates for every classification of employment mentioned in subsection 7 of section VI-B are replaced by the following: Occupation: weekly wages \"a) 1.Manager.$63.00 2.Chief accountant.56.00 3.Head sales clerk.56.00 4.Head warehouse-clerk: 1st year.45.00 2nd year.49.50 b) Delivery man.45.00 c) Delivery man's helper: (under 21 years of age).28.00 21 years or over.\u2022.34.50 d) Male office employees: 1st year.20.50 2ndvear.25.00 3rd year.28.50 2468 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S août 1953, Tome 85, N° 82 lème année.33.00 ôeme année.37.50 Oèine année.42.50 7ème année.^.47.50 Sème année.51.50 c) Employé il'entrepôt: lèrect2ème années d'expérience 35.00 après 2 ans d'expérience.41.00 /) Employé temporaire (l'heure).0.90 tj) Personnel féminin de bureau: 1ère année.20.50 2èmc année.24.50 3ème année.28.50 4ème année.32.50\" Les parties contractantes ont consenti à ce que ces amendements soient obligatoires à compter du 1er juin 1953.(Document \"G\" annexé à l'arrêté).Le Greffier suppléant du Conseil Exécutif, 35298-0 C.LARICHELIÈRE.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 886 Québec, le 30 juillet 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverncur-en-Conseil.Section \"F\" Concernant uir amendement au règlement de prélèvement du comité paritaire de l'industrie du camionage de l'Ile de Montréal.Il est onno.nnk, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que le paragraphe \"b\" de l'article 1 (Cotisation) du règlement de prélèvement du comité paritaire de l'industrie du camionnage de l'Ile de Montréal, approuvé par l'arrêté-en-conseil numéro 286-A du 12 mars 1953, soit remplacé par le suivant: \"b) Les artisans régis par ledit décret numéro 913, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 14 de 1% du salaire établi dans le décret pour leur métier ou occupation.\" C.LARICHELIÈRE, 35298-0 Greffier suppléant du Conseil Exécutif.4thyear.33.00 5thycar.37.50 Othyear.42.50 7thyear.47.50 Sthyear.51.50 c) Warehouse employee: 1st and 2nd years experience.35.00 After 2 years experience., .41.00 /) Temporary employee (per hour) .0.90 g) Female office employees: 1st year.20.50 2nd year.24.50 3rd year.28.50 4th year.32.50\" The contracting parties arc agreed that these amendments shall come into force starling June 1st, 1953.(Document \"G\" annexed to the Order).C.LARICHELIÈRE, 35298-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 886 Quebec, July 30, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"F\" Concerning an amendment of the levy by-law of the Trucking Industry Committee fot the Island of Montreal.It is ordered, on the recommendation of the Honourable Prime Minister, That subsection \"6\" of section 1 (Assessments) of the levy by-law, of the Trucking Industry Parity Committee for the Island of Montreal, approved by Order-in-Council No.286-A of March 12, 1953, be replaced by the following: \"b) The artisans governed by the said decree No.913 shall pay fo the Parity Committee an amount equivalent to ]/%.of 1 % of the wages established in the decree for their trade or occupation.\" C.LARICHELIÈRE, 35298-0 Acting Clerk of the Executive Council.Assemblée (P.G.5752-50) Clairol Inc.of Canada- Extrait des minutes de l'assemblée du bureau de direction de \"Clairol Inc.of Canada\" tenue le 2ième jour de juillet 1953, lesquelles ont été approuvées, sanctionnées et confimées à l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue à la même date.Il a été résolu que l'article 30 du règlement N° I se lisant comme suit: Règlement N° I Article 30.L'année fiscale de la compagnie se terminera le 31ième jour de juillet de chaque année.Le président a déclaré qu'en vu du changement de la fin de l'année fiscale de la compagnie au 31 juillet, il serait nécessaire d'amender l'article 5 du règlement N° I changeant la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.Sur Meeting (A.G.5752-50) Clairol Inc.op Canada Extract from the minutes of the meeting of the Board of Directors of Clairol Inc.of Canada held on the 2nd day of July 1953 which were approved, sanctioned and confirmed at the special general meeting of shareholders held on the same date.It was resolved that Article 30 of By-Law No.I reading as follows: By-Law No.I Article 30.The fiscal year of the Company shall terminate on the 31st day of July in each year.\" The Chairman then stated that due to the change of this Company's fiscal year end to 31st July, it would be necessary to amend Article 5 of By-Law No.I changing the date of the Annual General Meeting of Shareholders.Upon QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.86, No.82 2469 proposition dûment faite, secondée et adoptée à l'unanimité: Il a été résolu que l'article 5 du règlement N°l se lisant comme suit: Règlement N° I Article 5.L'Assemblée annuelle sera tenue au siège social de la compagnie en la cité de Montréal, province de Québec, à une date devant être fixée par les directeurs entre le premier et le trentième jour de mars de chaque année.soit amendé pour se lire comme suit:\" Règlement N° I Article 5.L'assemblée annuelle sera tenue au siège social de la compagnie en la cité de Montréal, province de Québec, à une date (pas plus tard que quatre mois à compter de la fin de l'année fiscale de la compagnie) que le bureau de direction pourra déterminer.Daté à Montréal, P.Q., ce 20ième jour de juillet 1953.Certifié vraie copié.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 35299 HAROLD T.GREETHAM.Avis divers motion, duly made, seconded and unanimously carried: It was resolved that Article 5 of By-Law No.I reading as follows: By-Law No.I Article 5.The annual meeting shall be held at the head office of the Company in the City of Montreal, in the Province of Quebec, on a date to be fixed by the directors between the first and the thirtieth day of March in each year, be amended to read as follows: By-Law No.I Article 5.The annual meeting shall be held at the head office of the Company in the City of Montreal, in the Province of Quebec, on a date (not later than four months reckoning from the end of the company's fiscal year) as the board of directors may determine.\" Dated at Montreal, P.Q., this 20th day of July 1953.Certified true Copy.(Seal) HAROLD T.GREETHAM.35299-0 Secretary-Treasurer.Miscellaneous Notices Loi du régime des eaux courantes, statuts Refondus, 1941, chapitre 98, Formule 2.2.\u2014 (Article 85) Avis de la demande du dépôt des plans et devis Avis est donné au public conformément à l'article 35 de la Loi du régime des eaux courantes, que, Donnacona Paper Company Limited, de la cité de Québec, dans le comté de Québec, se propose de faire les travaux suivants: Réparer l'écluse pour le flottage du bois au Grand Lac à l'Epaule, Rivière Jacques-Cartier, Parc National des Laurcntides.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin accompagnée des plans et devis indiquant la nature de l'ouvrage (ou de l'amélioration, selon le cas), et les terrains qui seront affectés par ces travaux, a été transmise au ministre des Ressources hydrauliques, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la division d'enregistrement de Montmorency, à Château-Richer.La demande contenue dans la requête sera prise en considération par lc Lieutenant-Gouverneur en Conseil le ou après le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Le 30 juillet 1953.DONNACONA PAPER CO.LTD.Par le Gérant du Bois, 35300-o W.F.McCOLM.(P.G.4518-47) Harvtne Mfg.Co.Ltd.Règlement N° 26 Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs.Qu'il soit résolu que: Water-Course Act, Revised Statutes.1941, Chapter 98, Form 2.2.\u2014 (Section 85) Notice of Application and Deposit of Plan and Specifications.Public notice is hereby given, in accordance with section 35 of the Water-Course Act, that Donnacona Paper Company Limited, of the City of Quebec in the county of Quebec, intends to execute the following work: Repair the driving dam of Big Lake L'Epaule, Jacques-Cartier River, Laurentide National Park.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications showing the nature of the work or of the improvement (as the case may be), and the land which will be affected by such work has been forwarded to the Minister of Hydraulic Resources, and that a duolicate of such plan and specifications has been deposited at the registry office of the registration division of Montmorency at Château-Richer.The application contained in the petition will be taken into consideration by the Lieutenant-Governor in Council on or after the tenth day following the date of the publîcztion of this notice in the Quebec Official Gazette.July 30, 1953.DONNACONA PAPER CO.LTD.W.F.McCOLM.35300-o Woodlands Manager, (A.G.4518-47) Harvine Mfg.Co.Ltd.By-Law No.26 By-law to increase the number of directors.Be it resolved that: 2470 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 32 1.Le nombre des directeurs de la compagnie 1.The number of directors of the Company soit augmenté de trois (8) à quatre (4).be increased from three (3) to four (4).2.Les règlements de la compagnie soient et 2.The By-laws of the Company be, and they ils sont, par les présentes, amendés pour se con- are hereby amended-to accord with the foregoing, former au précédent.\u2022 Décrété ce lôièiue jour de juin 1953.Enacted this lôth day of June, 1953.Le Secrétaire, IRVING MESHWORK, 35301 IRVING MESHWORK.353()l-o Secretary.(1*.G.6148-44) Precision Instruments incorporated Instruments de precision incorporée Règlement Spécial \"A\" (A.G.6148-44) Precisions instruments incorporated Instruments de precision incorporée Special By-Law \"A\" \"Que le nombre des directeurs de la compagnie \"That the number of Directors of the company soit porté de trois à cinq et que le règlement V be carried from throe to five and that By-law V des règlements généraux de la compagnie soit of the general by-laws of the company be and et est par la présente modifié en remplaçant le is by these presents amended by replacing the mot \"trois\" par le mot \"cinq\".\" work \"three\" by the word \"five\".\" Certifiée copie conformé, Montréal, le 17 juillet Certified true copy, Montreal, July 17, 1953.1953.Le Secrétaire, MARCEL PICHÉ, Q.C, 35302-o MARCEL PICHÉ, C.R.35302 Secretary.Westmore Fabrics Inc.Règlement spécial \"A\" La distribution de l'actif de la compagnie entre les actionnaires au pro rate du nombre d'actions détenues par chacun est, par les présentes, autorisée.Certifié vrai sommaire du règlement spécial \"A\" de \"Westmore Fabrics Inc.\" St-Hyacinthe, P.Q., 30 juillet 1953.Le Secrétaire, 35303 B.H.WELCH.Westmore Fabrics Inc.Special By-Law \"A\" The distribution of the assets of the Company amongst the Shareholders ratably to the number of shares held by each is hereby authorized.Certified true summary of Special By-law \"A\" of \"Westmore Fabrics Inc.\" St.Hyacinthe, P.Q., July 30, 1953.B.H.WELCH, 35303-o Secretary.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Coopérative d'Habitation St-Eusèbe de Montréal\", en date du 23 juillet 1953, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 29 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35310-o JEAN BRUCHÉSI.Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le 24 juillet 1953, le changement de nom du \"Syndicat des Employés des Industries de la Pâtisserie et de la Biscuiterie de Québec\", dont la formation a été autorisée le 8 novembre 1951, et sont le siège sscial est situé à Québec, dans le district judiciaire de Québec, en celui de \"Syndicat des Industries de la Pâtisserie et de la Biscuiterie Inc.\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q.1941, chapitre 162).Donné au bureau du Secrétaire de la province le 27 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la province, 35311 -o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Coopérative d'Habitation St-Eusèbe de Montréal\" dated July 23, 1953 whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial .Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, July 29, 1953.JEAN BRUCHÉal, 35310 Under Secretary of the Province.Notice of change of name (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized on July 24, 1953, the changing of the name \"Syndicat des Employés des Industries de la Pâtisserie et de la Biscuiterie de Québec\", the formation of which was authorized on November 8, 1951, and whose office is situate at Quebec, in the judicial district of Quebec, into that of \"Syndicat des Insdustries de la Pâtisserie et de la Biscuiterie Inc.\", and such pursuant to the provisions of sections 7 and following of the Professional Syndicates' Act (R.S.Q.1941, chapter 162).Given at the office of the Provincial Secretary, July 27, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35311 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1953, Vol.85, No.82 2471 \" Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 23 juillet 1953, les amendements apportés aux articles 21, 28, 01, 66, 74 et 78 des règlements de \"La Corporation Générale des Instituteurs et Institutrices Catholiques de la Province de Québec\", tels qu'adoptés «à l'assemblée tenue le 4 juillet 1953, et ce, conformément aux dispositions.de la loi 10, George VI, chapitre, 87, telle que modifiée par la loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 130.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 31 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la province, 3531 G-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Marchands Détaillants de St-Félicien\", pour l'étude, la défense et le develop- ¦ pement des intérêts économiques, sociaux et motaux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-sept juillet 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Félicien, dans le comté de Roberval.Le Sous-secrétaire de la Province, 33317-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Chantier Coopératif de l'U.C.C.de St-Magloire\", en date du 27 juin 1953, dont le siège social est situé à Saint-Ma-gloire, dans le comté de Bellechasse.et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 16 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35319-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Fraternité des Propriétaires de Taxis de Montréal\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 17 juillet 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la Province, 35320-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.14244-53) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 4 août 1953, les règlements I à XIV inclusivement de la \" Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.\", et leurs amendements, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 4 août 1953.' Le Sous-secrétaire de la province, .35325-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary approved, on July 23, 1953, the amendments to articles 21, 28, 61, 66, 74 and 78 of the By-laws of \"La Corporation Générale des Instituteurs et Institutrices Catholiques de la Province de Québec\", as adopted at a meeting held on July 4, 1953, and such, pursuant to the provisions of Act 10, George VI, Chapter 87, as modified by Act 1-2 Elizabeth II.Chapter 130.Given at the office of the Provincial Secretarv, July 31, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35316 Under Secretary of the*Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Marchands Détaillants de St-Félicien\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretarv on Julv twenty-seventh 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at St-Félicien, in the county of Roberval.JEAN BRUCHÉSI, 35317 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Chan-tier Coopératif de l'U.C.C.de St-Magloire\", under date the 27th day of June 1953 whereof the head office is at Saint-Magloire, in the county of Bellechasse and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 16th day of July, 1953.JEAN BRUCHÉSI, .35319 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Fraternité des Propriétaires tie Taxis de Montréal\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of the profession, has been authorized by the Provincial Secretary on July 17, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI.35320 Under Secretary of the Province.(A.G.14244-53) Notice is hereby given that, under the recommendation of the Deputy-Attornej General, By-laws I to XIV inclusively of the \"Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.\", and their amendments, were approved by the Honourable, the Provincial Secretary, on August 4, 1953, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Se- .cretary.this 4th dav of August, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35325 Under Secretary^ the Province. 3472 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 86, N° 82 (P.G.\u202214244-53) i Avis est donné que, sur la recommandation de I*Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 4 août 1953, les règlements comprenant les articles 1 à 52 inclusivement de la \"Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.\", tels qu'adoptés le 9 juin 1953, et ce conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 4 août 1953.Le Sous-secrétaire de la province, 35325-0 JEAN BKUCHÉSI.Chartes \u2014 Abandon de Avis est donné que la compagnie \"Alliance Export & Import Co.Inc.\" demandera la permission d'abandonner sa charte, en vertu des dispositions de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec, à compter d'une date qu'il plaira à l'Honorable Lieutenant-gouverneur en Conseil se fixer.Montréal, 30 juillet 1953.Les Procureurs de la requérante.(Signé) SCHWISBERG & SCHWISBERG.35304 Hanson Bros.Realty Corporation Avis est donné que la compagnie \"Hanson Bros.Realty Corporation\" a l'intention de demander au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte pour annulation.Montréal, P.Q., 29 juillet 1953.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 35305 E.W.ALEXANDER.Canada, Province de Québec, district de Montréal \"Lachine Golf & Country Club Inc.\" corps politique et dûment incorporé, ayant son siège social à Lachine dans le district de Montréal.AVIS Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Lachine Golf & Country Club Inc.,\" une corporation constituée selon la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social dans la cité de Lachine, district de Montréal, s'adressera à l'honorable Procureur Général de la Province de Québec pour être autorisée à abandonner sa charte selon les prescriptions de la Loi des Compagnies de Québec.Daté en la cité de Lachine, ce 15ème jour de juillet 1953.Le Secrétaire, 35306-o MARCEL-E.LEGAULT.AVIS Avis est par les présentes donné que les \"Ateliers Mécaniques de Sorel, Limitée\", \"Sorel Mechanical Shops Co., Ltd.\" constituée en corporation par Lettres Patentes en date du 1er mai 1914, s'adressera au Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce, conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies de Qué- (A.G.14244-53) Notice is hereby given that, under the recommendation of the Deputy-Attorney General, By-laws comprising article 1 to 52 inclusively, of the \"Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Française, Inc.\", as adopted on June 9, 1953, were approved by the Honourable the Provincial Secretary, on August 4, 1953, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of August, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35325 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of Notice is hereby given that \"Alliance Export & Import Co.Inc.\" will apply, under the provisions of S.26, Quebec Companies Act, for leave to surrender its Charter, on a date to be fixed by the Honourable the Lieutenant-Governor in Council.' Montreal, July 30th, 1953.(Sgd) SCHWISBERG & SCHWISBERG, Attorneys for Applicant.35304-o Hanson Bros.Realty Corporation Notice is hereby given that \"Hanson Bros.Realty Corporation\" intends to make application to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter for cancellation.Montreal, P.Q., July 29th, 1953.(Seal) E.W.ALEXANDER.35305-o Secretary-Treasurer.Canada, Province of Quebec, district of Montreal- \"Lachine Golf & Country Club Inc.\" a body corporate and duly incorporated, having its principal place of business in the city of Laehi-ne, district of Montreal.NOTICE Notice is hereby given that the \"Lachine Golf & Country Club Inc.\", a corporation constituted under the Quebec Companies Act and having its head office in the City of Lachine, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Lachine, this 15th, day of July, 1953.MARCEL-E.LEGAULT, 35306-o Secretary.NOTICE Notice is hereby given that the \"Ateliers Mécaniques de Sorel, Limitée\", Sorel Mechanical Shops Co., Ltd.\", incorporated by Letters Patent bearing date May 1st, 1914, will apply to the Attorney General and to the Minister of Municipal Affairs, and the Minister of Trade and Commerce, in conformity with the provisions of the Quebec Companies Act, for leave to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE; Quebec, August 8th, 1958, Vol.85, No.82 2473 bec, pour demander l'abandon de sa charte et son annulation à compter de la date qu'il plaira audit Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce de fixer.Daté à Montréal, P.Q., ce 4 août 1953.\"Ateliers Mécaniques de Sorel Limitée\" (Sorel Mechanical Shops Co., Ltd), Le Secrétaire-suppléant, 35326-o C.HAWKEN.AVIS Avis est par les présentes donné que \"Les Chantiers Manseau Limitée\", \"Manseau Shipyards Limited\", constituée en corporation par Lettres Patentes en date .du 23 mars 1927, s'adressera au Procureur Général et au Ministre des Affaires.Municipales, conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies de Québec, pour demander l'abandon de sa charte et son annulation à compter de la date qu'il plaira audit Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce de fixer.Daté à Montréal, P.Q., ce 4 août 1953.\"Les Chantiers Manseau Limitée\" (Manseau Shipyards Limited), Le Sécrétai re-suppléant, 35327-o C.HAWKEN.surrender its charter and to obtain its cancellation from and after whatever date it shall please the Attorney General of Municipal Affairs, Trade and Commerce, to determine.Dated at Montreal, P.Q., this 4th day of ' August, 1953.\"Ateliers Mécaniques de Sorel Limitée\" (Sorel Mechanical Shops Co., Ltd.) C.HAWKEN, 35326 Acting Secretary.NOTICE Notice is hereby given that \"Les Chantiers Manseau Limitée\", \"Manseau Shipyards Limited\", incorporated by Letters Patent bearing date the twenty-third day of March, 1927, will apply to the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, in conformity with the provisions of the Quebec Companies' Act, for leave to surrender its charter and obtain its cancellation from and after whatever date it shall please the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, to determine.Dated at Montreal, P.Q.this 4th day of August, 1953.\"Les Chantiers Manseau Limitée\" (Manseau Shipyards Limited), C.HAWKEN, 35327 Acting Secretary.Commission Municipale de Québec Paroisse de Saint-Camille-de-Lelus (Bellechasse) Avis public est par les présentes donné que la Commission municipale de Québec, î\\ sa séance en date du 3 août 1953, a adopté la résolution suivante: .\"Il est résolu que, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, c.207), la corporation de la paroisse de Saint-Camillc-de-Lcllis, dans le comté de Bellechasse, ne soit plus, à compter du 1er septembre 1953, considérée comme étant en défaut au sens de la section V de ladite loi.\" Québec, le 4 août 1953.La Commission municipale de Québec, ' Le Secrétaire, 3532 l-o MAURICE R.MARCOTTE.Quebec Municipal Commission Parish op St.Camille de Lellis (Bellechasse) Public Notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission has adopted the following resolution at its sitting of August 3, 1953: \"Resolved that in accordance with the provisions of Section 52 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, C.207), the Corporation of the Parish of St.Camille de Lellis, in the county of Bellechasse, shall, from and after September 1, 1953, no longer be considered in default within the meaning of Division V of the said act.\" Quebec, August 4, 1953.Quebec Municipal Commission, MAURICE R.MARCOTTE, 35321-0 Secretary.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.2185-53) Avis est donné que la compagnie \"Yellow Manufacturing Acceptance Corporation\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie par sa charte seront limités à ceux -accordés aux corporations de même nature créées en vertu des Lois de la province de Québec, et la compagnie sera sujette aux mêmes formalités telles que prescrites par les Lois existantes de cette Province.Le bureau principal de la corporation dans la Province sera établi à 2000 édifice Aldred, 507 Company Licensed to do Business (P.Sec.2185-53) Notice is hereby given that \"Yellow Manufacturing Acceptance Corporation\" has been licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred on the said Company by its charter shall be limited to those granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quebec, and the Company shall be subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The principal office of the Corporation in the Province is to be established at 2000 Aldred 2474 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1968, Tome 86, N° 82 Place d'Armes, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal dans la Province, aux fins d recevoir les assignations dans toute poursuite ou procédure prise contre elle, est M.W.H.Laidley, de l'adresse donnée ci-dessus.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 3ième jour d'août 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35297 JEAN BRUCHÉSI.Compagnie dissoute (P.G.8085-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"St.Laurent Drive Yourself Ltd\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 15 mars 1951.Avis est de plus donné qu'à compter du premier août 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 août 1953.L'Assistant-procureur général, 35297-0 L.DÊSILETS.Département du Travail ERRATA Le Code de sécurité pour ascenseurs et monte-charge, approuvé par l'arrété-en-conseil numéro 1171, du 6 novembre 1952, publié dans l'édition du 25 avril 1953 de la Gazette officielle de Québec, est corrigé comme suit: 1° Le deuxième alinéa de l'article 1-9 est radié.2° Le mot \"from\" à Payant dernière ligne de l'article 1-58, version anglaise, doit se lire \"free'.' 3° Les mots \"de la définition ci-dessus\", apparaissant à l'article 1-77, sont remplacés par les mots \"définies au paragraphe 21\".4° Les mots \"(paragraphe 82),, sont ajoutés après le mot \"verrouillage\" apparaissant à l'article 1-78.5° Les mots \"de la définition ci-dessus\" ap-raissant à l'article 1-79, sont remplacés par les mots \"définies au paragraphe 21\".6° Les mots \"défini ci-dessus\", apparaissant à l'article 1-80, sont remplacés par les mots \"(paragraphe 82)\".7° Les mots \"à l'article 18\", mentionnés au deuxième alinéa de l'article 17-b, sont remplacés par les mots \"à l'article 27\".8° Le mot \"manuellement\" apparaissant au deuxième alinéa du paragraphe \"e\" de l'article 17 est radié.9° Le mot \"which\" est ajouté après les mots \"sides of the door\" apparaissant dans la version anglaise du troisième alinéa du paragraphe \"e\" de l'article 17.10° Les mots \"opening and shall, except at bottom landing' 'sont ajoutés, dans la version anglaise du paragraphe \"d\" de l'article 22, après les mots \"width of the landing\".11° Le mot \"which\" est ajouté, dans la version anglaise du paragraphe \"g\" de l'article 22, après les mots \"except that elevators\".Bldg., 507 Place d'Armes, in the City and Judicial District of Montreal.Its chief agent in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding against it is Mr.W.H.Laidlcy, of the above given adress.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of August, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35297-Q Under Secretary of the Province.Company Dissolved (A.G.8085-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"St.Laurent Drive Yourself Ltd\" incorporated by letters patent dated March 15, 1951.Notice is also hereby given that from and after the First day of August 1953, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this third day of August, 1953.L.DÊSILETS, 35297 Deputy Attorney General.Department of Labour ERRATA The Safety Code for Elevators and Hoists, approved by Order in Council No.1171 of November 6,'1952, and published in the Quebec Official Gazette, issue of April 25, 1953, is corrected as follows: 1° The second paragraph of article 1-9 is deleted.2° The word \"from\" in.the second last line of article 1-58 should read \"free\".3° The word \"above\" mentioned in article 1-77 is replaced by the words \"as indicated in paragraph 21\".4° The words \"(paragraph 82)\" are added after the words \"definition of interlock\" mentioned in article 1-78).5° The word \"above\" mentioned in article 1-79 is replaced by the words \"as indicated in paragraph 21\".6° The word \"above\" mentioned in article 1-80 is replaced by the words \"(paragraph 82)\".7° The words \"in article 18\" mentioned in the second paragraph of article 17-b are replaced by the words \"in article 27\".8° The word \"manuellement\", mentioned in the French version of the second paragraph of article 17-e, is deleted.9° The word \"which is added after the words \"sides of the door\" mentioned in the third paragraph of article 17-e.10° The words \"opening and shall, except at bottom landing\" are added, in paragraph \"a\" of article 22, after the words \"width of the landing\".11° The word \"which\" is added, in paragraph \"g\" of article 22, after the words \"except that elevators\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1958, Vol.85, No.82 2475 12° Le mot \"door\" est ajouté, dans la version anglaise du paragraphe \"g-1\" de l'article 27, après les mots \"if a car\".13° Les mots \"if or one of these doors\", ap-raissant dans la version anglaise du Sème alinéa du paragraphe \"g\" de l'article 27, sont remplacés par les mots \"or if one of these doors\".14° A l'article 40, version anglçise, les mots \"They shall conform to the Parts I, II and IV\" sont remplacés par les mots \"They shall conform to Parts n, HI, TV, V, VI and VII\".15° A l'article 51, les mots \"contenues à la section rV\" sont remplacés paroles mots \"contenues aux sections II, III et TV\".16° Au paragraphe \"e\" de l'article 55j les mots \"devront toucher le fond de la fosse avant que le contrepoids\" sont ajoutés après les mots \"que la cabine' ou le' contrepoids\".17° A l'article 122, la deuxième ligne est remplacée par la suivante: \"des petits monte-charge doivent être pourvues\".Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 8 août 1953.35298-o AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes que la constitution et les règlements du Comité conjoint de la construction de Rimouski, formé en exécution du décret numéro 802 du 8 juillet 1953, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 886-C du 30 juillet 1953.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 8 août 1953.35298-o AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENTS L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes que la constitution et les règlements du Comité conjoint de l'industrie de la construction de Québec, formé en exécution du décret numéro 760 du 30 juin 1953, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 886-A du 30 juillet 1953.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 8 août 1953.35298-0 AVIS DE PRÉLÈVEMENT.L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'Industrie de la Construction de Québec, établi en exécution du décret numéro 760 du 30 juin 1953, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté-en-conseil numéro 886 du 30 juillet 1953 section \"B\", le tout conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de la publication du présent règlement dans la 12° The word \"door\" is added, in paragraph \"g-1\" of article 27, after the words \"if a car\".13° The words \"if or one of these doors\", mentioned in the 8th paragraph of article 27-g, are replaced by the words \"or if one of these doors\".14° In article 40, the words \"They shall conform to the Parts I, II and IV\" are replaced by the words \"They shall conform to Parts II, m, TV, V, VI and VU\".15° In article 51, the words \"under the part IV\" are replaced by the words \"under the parts II, III and IV\".16° In paragraph V of article 55, in the French version, the words \"devront toucher le fond de la fosse avant que le contrepoids\" are added after the words \"que la cabine ou le contrepoids\".17° In article 122, French version, the second line is replaced by the following: \"des petits monte-charge doivent être pourvus\".GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 8, 1953.35298-o NOTICE OF APPROVAL OF BY-LAWS The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the constitution and by-laws of the Construction Joint Committee of Rimouski, formed under decree No.802 of July 8, 1953, have been approved by Order-in-Council No.886-C of July 30, 1953.GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 8, 1953.35298-o NOTICE OF APPROVAL OF BY-LAWS The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the constitution and by-laws of the Joint Committee of the Construction Industry, Quebec, formed under decree No.760 of June 30, 1953, have been approved by Order-in-Council No.886-A of July 30, 1953.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 8, 1953.35298-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister oa Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Construction Industry of Quebec, established under decree number 760 of June 30, 1953, has been authorized by a bylaw approved by Order-in-Council number 886, of July 30, 1953, part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941.chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessmefits The period of levy extends from the date of publication of the present by-law in the Quebec 2476 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 82 Gazette officielle de Québec au 30 avril 1954; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné.* a) Tous les employeurs professionnels i the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.PROCLAMATION L.Désilets, /VLT'HEREAS in accordance Deputy Attorney) W wjth Section 44 of the General.\\ Courts of Justice Act (Revised (Statutes, 1941, Chapter 15), amended by Section 2 of Act 15-16 George VI, Chapter 31, the Superior Court sitting in the district of Trois-Rivières has concurrent jurisdiction with the Superoir Court sitting in the district of Quebec, over that part of the electoral district of Laviolette included in the judicial district of Quebec; Whereas under authority of Section 46 of Courts of Justice Act, amended by Section 2 of Act 1-2 Elizabeth II, Chapter 29, the Lieutenant-Governor may order, by proclamation, that the terms and sittings of the Superior Court and of the judges thereof, be also held in a locality of the judicial district other than that in which the chief-place is situated, or in a locality of another judicial district where said Court has concurrent jurisdiction, and that such proclamation shall describe the place and building where terms and sittings of said Court and judges thereof, shall be held.Whereas following such proclamation, and according to the law, all juridical days shall be term days, without prejudice to the provisions of Article 15 of the Code of Civil Procedure; Whereas it is deemed expedient to ordain: a) That the terms and sittings of the Superior Court of the district of Trois-Rivières, and judges thereof be also held at La Tuque, a town situated 2482 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1968, Tome 86, N° 8£ située dans la partie du district électoral de La-violettcjcomprise dans le district de Québec et sur laquelle la Cour supérieure du district des Trois-Rivières a\" juridiction concurrente avec la Cour supérieure du district de Québec; b) Que l'édifice où siège le conseil municipal de la ville de La Tuque soit désigné comme étant l'immeuble où doivent être tenus les termes et séances de cette cour et de ses juges.A ces causes, de l'avis et du consentement de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 820, en date du 16 juillet 1953, et conformément aux dispositions de l'article 46 de la Loi des tribunauxjudiciaires, (S.R.Q.1941, chapitre 15), modifié par l'article 2 de la loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 29, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que les termes et séances de la Cour supérieure du district des Trois-Rivières et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans la ville de La Tuque, dans l'édifice où siège le conseil municipal de cette ville.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de la province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-neuvième jour de juillet en l'année mil neuf cent cinquante-trois de l'ère chrétienne et de Notre Règne la deuxième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 35297-o JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi.\tJuly 1st, 1967 16,000\t00\tJuly 1st, 1968 17,000\t00\tJuly 1st, 1969 18,000\t00\tJuly 1st, 1970 18,000\t00\tJuly 1st, 1971 19,000\t00\tJuly 1st, 1972 20,000\t00\tJuly 1st, 1973 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1953, Vol 85, No.32 2485 échéances les plus éloignées et les numéros les redemption will be in reverse order of maturity plus élevés.and serial number.Chaque soumission devra être accompagnée Each tender must be accompanied by an ac- (j'un chèque accepté égal à 1% du montant de cepted cheque equal to 1% of the amount of l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- the loan and must specify whether the price of- prend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur fered includes or does not include accrued interest les obligations au moment de la livraison.on the bonds to time of their delivery.Les soumissions seront ouvertes et considérées Tenders will be opened and considered at a à une séance du conseil qui sera tenue lundi le meeting of the council, to be held on Monday, 24 août 1953 à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville August 24th, 1953, at 8 o'clock p.m., at the city de Joliette.Hall of the city of Joliette.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni The Council does not bind itself to accept the la plus haute ni aucune des soumission.highest nor any of the tenders.Joliette (comté de Joliette) ce vingt-deux juillet Joliette (County of Joliette) July twenty- 1953.second 1953.Le Secrétaire-trésorier, RAOUL JETTE, RAOUL JETTE.Secretary-treasurer.Hôtel de Ville, CP.69.City Hall P.O.69.Joliette, (Joliette) 35309-o Joliette (Joliette) 35309-o Province de Québec Les Commissaires d'Écoles pour la Municipalité du village de Saint-Martin * (Comté de Laval) Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of the village of SaINT-MaRTIN (County of Laval) Avis public est par les présentes donné que des Public notice is hereby given that sealed soumissions cachetées et endossées \"Soumissions tenders, endorsed \"Tenders for bqnds\" will be pour obligations\" seront reçues par le soussigné, received by the undersigned Léo Taillefer, secre-Léo Taillefer, secrétaire-trésorier, rue de l'Église, tary-treasurcr, Church Street, Saint-Martin, Saint-Martin, comté de Laval, jusqu'à 8 heures county of Laval, until 8 o'clock p.m., Monday, p.m., lundi, le 24 août 1953, pour l'achat de August 24, 1953, for the purchase of an issue of $270,000.00 d'obligations des commissaires d'éco- $270,000.00 of bonds of the School Commissioners les pour la municipalité du village de Saint- for the Municipality of the village of Saint-Mar-Martin, comté de Laval, datées du 1er juillet tin, county of Laval, dated July 1st, 1953 and 1953 et remboursable par séries du 1er juillet redeemable serially from July 1st, 1954 to July 1954 au 1er juillet \"1973 inclusivement, avec 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate not intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur less than 3% nor more than 43^% per annum, à 4J^% par année payable semi-annuellement les payable semi-annually on January 1st and July 1er janyier et 1er juillet de chaque année.Le 1st of each year.The rate of interest may be taux d'intérêt peut être le même pour toute the same for the whole issue or it may vary l'émission ou il peut' varier suivant les échéances, according to maturities.The table of redemp-Le tableau d'amortissement est le suivant: tion is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $270,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juillet.1954.x $16,000.00 1er juillet 1955.x 16,500.00 1er juillet 1956.x 17,500.00 1er juillet 1957.x 18,000.00 1er juillet 1958.x 19,000.00 ,1er juillet 1959.x 20,000.00 1er juillet 1960.«.x 21,000.00 1er juillet 1961.x\" 21,500.00 1er juillet 1962.x 22,500.00 1er juillet 1963.x 23,500.00 1er juillet 1964.6,000.00 1er juillet 1965.6,500.00 1er juillet 1966.6,500.00 \u20221er juillet 1967.7,000.00 1er juillet 1968.7,000.00 1er juillet 1969.7,500.00 1er juillet 1970.8,000.00 1er juillet 1971.8,500.00 1er juillet 1972.8,500.00 1er juillet 1973.9,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $187,200, accordé par le Secrétaire de la province et payable en dix versements de $18,720 chacun, de 1954 à 1963 inclusivement, seront reçue et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y alieu, par chèque visé payable au pair à Saint-Martin, comté de Laval.Table of redemption \u2014 $270,000.00 \u2014 20 years Year Capital July 1st, 1954.x $16,000.00 July 1st, 1955.x 16,500.00 July 1st, 1956.x 17,500.00 July 1st, 1957.x 18,000.00 July 1st, 1958.x 19,000.00 July 1st, 1959.x 20,000.00 July 1st, 1960.x 21,000.00 July 1st, 1961.x 21,500.00 July 1st, 1952.x 22,500.00 July 1st, 1963.x 23,500.00 July 1st, 1964.6,000.00 July 1st, 1965.5,500.00 July 1st, 1966.6,500.00 July 1st, 1967'.7,000.00 July 1st, 1968.7,000.00 July 1st, 1969.7,500.00 July 1st, 1970.8,000.00 July 1st, 1971.8,500.00 July 1st, 1972.8,500.00 July 1st, 1973.9,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $187,200, granted by the Provincial Secretary and payable in ten instalments of $18.720 each, from 1954 to 1963 inclusively, shall be received and applied to the service of this loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Saint-Martin, county of Laval. 2486 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 82 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales d'une banque à charte dans la province de Québec.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 24 août 1953, à 8 heures p.m., à l'école Leblanc, à Saint-Martin, comté de Laval.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Martin, (Comté de Laval), ce 3 août 1953.Le Secrétaire-trésorier, LÉO TAILLEFER.Rue de l'Eglise, Saint-Martin, (Comté dcu Laval), P.Q., 3533l-o Province de Québec Ville de Jonquières (Comté de Chicoutimi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" -seront reçues par le soussigné, Paul-E.Fortin, greffier, Hôtel de Ville Jonquières, comté de Chicoutimi, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 24 août 1953, pour l'achat de $800,000.00 d'obligations de la ville de Jonquières, comté de Chicoutimi, datées du 1er septembre 1953 et remboursables par séries du 1er septembre 1954 au 1er septembre 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4/^% par année payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $800,000.00 \u2014 20 ans.Année\tCapital\t 1er septembre 1954.\t$24,000\t00 1er septembre 1955.\t25,500\t00 1er septembre 1956.\t26,500\t00 1er septembre 1957.\t28,000\t00 1er septembre 1958.\t29,500\t00 \t31,000\t00 1er septembre 1960.\t32,500\t00 1er septembre 1961.\t34,000\t00 1er septembre 1962.\t36,000\t00 1er septembre 1963.\t37,500\t00 1er septembre 1964.\t39,500\t00 1er septembre 1965.\t41,500\t00 1er septembre 1966.\t43,500\t00 1er septembre 1967.\t.45,500\t00 1er septembre 1968.\t48,000\t00 1er septembre 1969.\t50,000\t00 1er septembre 1970.\t53,000\t00 1er septembre 1971.\t55,500\t00 1er septembre 1972.\t58,000\t00 1er septembre 1973.\t61,000\t00 L'adjudicataire s'engage\tà payer les\tobliga- tions, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Jonquières, comté de Chicoutimi.Capital and interest are payable at all branches of any chartered bank in the Province of Quebec.The, said bonds are, under the authority of Chapter 212 Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, August 24, 1953, at 8 o'clock p.m., at the Leblanc School at St.Martin, county of Laval.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Saint-Martin, (County of Laval), August 3, 1953.LÉO TAILLEFER, Secretary-treasu rer.Church Street, Saint-Martin, (County of Laval), P.Q.35331 Province of Quebec Town of Jonquières \u2022 (County of Cliicoutimi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\", will be received by the undersigped Paul E.Fortin, clerk, Town Hall, Jonquières, county of Chicoutimi, until 8 o'clock p.m., Monday, August 24, 1953, for the purchase of an issue of $800,000.00 of bonds of the town of Jonquières, county of Chicoutimi dated September 1st, 1953 and redeemable serially from September 1st 1954 to September 1st, 1973, inclusively, with interest at a rate not less than 3% norover 4^% per annum, payable semi-annually on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $800,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1 st, 1954.$24,000.00 September 1st, 1955.25,500.00 September 1st, 1950 .26,500.00 September 1st, 1957 .28,000.00 September 1st, 1958 .29,500.00 September 1st, 1959.31,000.00 September 1st, 1960 .32,500.00 September 1st, 1961.34,000.00 September 1st, 1962 .36,000.00 September 1st, 1963 .37,500.00 September 1st, 1964.39,500.00 September 1st, 1965 .41,500.00 September 1st, 1966 .43,500.00 September 1st, 1967 .45,500.00 September 1st, 1968.48,000.00 September 1st, 1969 .50,000.00 September 1st, 1970.53,000.00 September 1st, 1971.55,500.00 September 1 st, 1972 .58,000.00 September 1st, 1973 .61,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Jonquières,.county of Chicoutimi. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1968, Vol.86, No.82 2487 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de deux banques à charte.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéances d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 24 août 1953, à 8 heures p.m., à la salle du conseil, à Jonquières, comté de Chicoutimi.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Jonquières, (Comté de Chicoutimi), ce 3 août 1953.Le Greffier, PAUL-E.FORTIN.Hôtel de Ville, Jonquières, (Comté de Chicoutimi), P.Q., 35328-0 Province de Québec Ville de La Tuque (Comté de Champlain) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, A.-A.Dupont, greffier, CP.544, Hôtel de Ville, La Tuque, comté de Champlain, jusqu'à 8 heures p.m., mardi, le 25 août 1953, pour l'achat de $375,000.00 d'obligations de la ville de La Tuque, comté de Champlain, datées du 1er septembre 1953 et remboursables par séries du 1er septembre 1954 au 1er septembre 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4^% par année payable semi-.annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Capital and interest are payable at any branch of two chartered banks in the Province of Quebec.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment jn reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, August 24, 1953, at 8 o'clock p.m., at the Council Hall at Jonquières, county of Chicoutimi.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Jonquières, (County of Chicoutimi), August 3rd, 1953.PAUL-E.FORTIN, Clerk.Town Hall, Jonquières, (County of Chicoutimi), P.Q.35328 Province of Quebec Town of La Tuque (County of Champlain) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned A.-A.Dupont, clerk, B.O.P.544, Town Hall, La Tuque, county of Champlain, until 8 o'clock p.m., Tuesday, August 25, 1953, for the purchase of an issue of $375,000.00 of bonds of the town of La Tuque, dated September 1st, 1953 and redeemable serially from September 1st, 1954 to September 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate not less than 3%, nor over 4J^% per annum, payable semi-annually on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $876,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er septembre 1954.$14,000.00 1er septembre 1955.15,000.00 1er septembre 1956.15,500.00 1er septembre 1957.16,500.00 1er septembre 1958.17,500.00 1er septembre 1959.¦ 18,000.00 1er septembre 1960.19,000.00 1er septembre 1961.19,500.00 1er septembre 1962.20,500.00 1er septembre 1963 .21,500.00 1er septembre 1964.16,000.00 1er septembre 1965.16,500.00 1er septembre 1966.17,500.00 1er septembre 1967.18,500.00 1er septembre 1968.19,000.00 1er septembre 1969.20,000.00 1er septembre 1970.21,000.00 1er septembre 1971.22,000.00 1er septembre 1972.23,000.00 1 er septembre 1973'.24,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à La Tuque, comté de Champlain.Table of redemption \u2014 $876,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1954.$14,000.00 September 1st, 1955.15,000.00- September 1st, 1956.15,500.00 September 1st, 1957.16,500.00 September 1st, 1958.17,500.00 September 1st, 1959.18,000.00 September 1st, 1960.19,000.00 September 1st, 1961.19,500.00 September 1st, 1962.20,500.00 September 1st, 1963.21,500.00 September 1st, 1964.16,000.00 September 1st, 1965.16,500.00 September 1st, 1966.17,500.00 September 1st, 1967.18,500.00 September 1st, 1968.19,000.00 September 1st, 1969.20,000.00 September 1st, 1970 .21,000.00 September 1st, 1971.22,000.00 September 1st, 1972 .23,000.00 September 1st, 1973 .24,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at La Tuque county of Champlain. 2488 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 32 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec, à La Tuque ainsi qu'à Toronto.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée «l'un chèque accepté égal à 1% du montant tic l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 25 août 1953, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville de La Tuque, comté de Champlain.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.La Tuque, (Comté de Champlain), ce 4 août 1953.Le Greffier, * A.-A.DUPONT.CP.544, Hôtel de Ville, La Tuque, (Comté de Champlain), P.Q.35329-0 Province de Québec Paroisse de St-Romuald d'Etçhemin (Comté de Lévis) Avis est public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Antoine Gosselin, secrétaire-trésorier, C.P.N° 7, St-Romuald d'Etçhemin, Cté Lévis, jusqu'à 8 heures p.m., mardi, le 25 août 1953, pour l'achat de §50,000 d'obligations de la paroisse de St-Romuald d'Etçhemin, comté de Lévis, datées du 1er septembre 1953 et embour-sables par séries du 1er septembre 1954 au 1er septembre 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 43^% par année payable semi-annuellemcnt les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 §50,000.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er septembre 1954.81,500.00 1er septembre 1955.1,500.00 1er septembre 1956.1,500.00 1er septembre 1957.2,000.00 1er septembre 1958.2,000.00 1er septembre 1959.2,000.00 1er septembre 1960.2.OD0.00 1er septembre 1961.2,000.00 1er septembre 1962.2,500.00 1er septembre 1963.2,500.00 1er septembre 1964.2,500.00 1er septembre 1965.2,500.00 1er septembre 1966.2,500.00 1er septembre 1967.3,000.00 1er septembre 1968.3,000.00 1er septembre 1969.3,000.00 1er septembre 1970.3,500.00 1er septembre 1971-.3,500.00 1er septembre 1972.3,500.00 1er septembre 1973.3,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par Capital and interest arc payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, at Quebec, at La Tuque as well a at Toronto.The said bonds arc, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be rcdemcd by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, August, 25 1953, at 8 o'clock p.m., at the town hall of La Tuque, county of Champlain.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.La Tuque, (County of Champlain), August 4, 1953.A.-A.DUPONT, Clerk.P.O.B.544, Town Hall, La Tuque, (County of Champlain), P.Q., 35329 Province of Quebec Parish of St-Romuald d'Etçhemin (County of Levis) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Antoine Gosselin, Secretary-treasurer, P.O.B.No.7, St.Romuald d'Etçhemin, Co.Levis, until 8 o'clock p.m., Tuesday, August 25, 1953, for the purchase of an issue of S50.000 of bonds of the parish of St.Romuald d'Etçhemin- County of Levis dated September 1st, 1953 and redeemable serially from September 1st, 1954 to September 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor over 4J^% per annum, payable semi-annually on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $50,000.00 \u2014 20 years.Year Capital September 1 st, 1954.$1,500.00 September 1 st, 1955.1,500.00 September 1st, 1956.1,500.00 September 1st, 1957.2,000.00 September 1st, 1958.2,000.00 September 1st, 1959.2,000.00 ' September 1st, 1960.2,000.00 September 1st, 1961.2,000.00 September 1st, 1962.2,500.00 September 1st, 1963.2,500.00 September 1st, 1964.2,500.00 September 1 st, 1965.2,500.00 September 1st, 1966.2,500.00 September 1st, 1967.3,000.00 September 1st, 1968.'.3,000.00 September 1st, 1969.3,000.00 September 1st, 1970.3,500.00 September 1st, 1971.3,500.00 September 1 st, 1972.3,500.00 September 1st, 1973.3,500.00 The successful tenderer agrees to pay the bonds, capital and accrued interest, if any, at par, at QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1963, Vol.86, No.32 2489 chèque visé, payable au pair à St-Romuald d'Etçhemin, comté de Lévis.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à St-Romuald d'Etçhemin, comté de Lévis.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas\" les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séanbe du conseil qui sera tenue mardi, le 25 août 1953, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville de St-Romuald d'Etçhemin, comté de Lévis.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Romuald d'Etçhemin (Comté de Lévis), ce 5 août 1953.Le Secrétaire-trésorier, ANTOINE GOSSELIN, C.P.N° 7, St-Romuald d'Etçhemin, (Cté Lévis), P.Q.35332-0 Province de\" Québec Village de Maniwaki (Comté de Gatincau) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Léo-Paul Grondin, secrétaire-trésorier, C.P.59, Hôtel de Ville, Maniwaki, Cté Gati-neau, jusqu'à 8 heures p.m.mercredi, le 2G août 1953, pour l'achat de 8180,000 d'obligations du village de Maniwaki, comté de Gatincau, datées du 1er septembre 1953 et remboursables par séries du 1er septembre 1964 au 1er septembre 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4)^%, par année payable semi-annucllcment les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $180,000.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er septembre 1954.S 5,500.00 1er septembre 1955.5,500.00 1er septembre 1956.6,000.00 1er septembre 1957.%.%.6,500.00 1er septembre 1958.7,000.00 1er septembre 1959.7,000.00 1er septembre 1960.7,500.00 1er septembre 1961.7,500.00 1er septembre 1962.8,000.00 1er septembre 1963.8,000.00 1er septembre 1964.8,500.00 1er septembre 1965.9,500.00 1er septembre 1966.10,000.00 1er septembre 1967.10,500.00 1er septembre 1968.11,000.00 1er septembre 1969.11,000.00 1er septembre 1970.11,500.00 1er septembre 1971.12,500.00 1er septembre 1972.\".13,000.00 1er septembre 1973.14,000.00 St-Romuald d'Etçhemin, County of Levis.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at St-Romuald d'Etçhemin, county of Levis.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, August, 25, 1953, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of St.Romuald d'Etçhemin, county of Levis.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Romuald d'Etçhemin (Countv of Levis) August 5, 1953.ANTOINE GOSSELIN, Secretary-Treasurer, P.O.B.No.7, St.Romuald d'Etçhemin, (Co.Levis), P.Q.35332 Province of Quebec Village of Maniwaki (County of Gatineau) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Léo-Paul Grondin, secretary-treasurer, P.O.B.59, Town Hall, Maniwaki, Co.Gatineau, until 8 o'clock p.m., Wednesday, August 26, 1953, for the purchase of an issue of 3180,000 of bonds of the village of Maniwaki County of Gatincau dated September 1st, 1953 and receemable serially from September 1st, 1954 to September 1st, 1973 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor over 43^% per annum, payable semi-annually on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $180,000.00 \u2014 20 years.Year Capital September 1st, 1954.8 5,500.00 September 1st, 1955.5,500.00 September 1st, 1956.6,000.00 September 1st, 1957.6,500.00 September 1st, 1958.7,000.00 September 1st, 1959.7,000.00 September 1st, 1960.7,500.00 September 1st, 1961.7,500.00 September 1st, 1962.8,000.00 September 1st, 1963.8,000.00 September 1st, 1964.8,500.00 September 1st, 1965.9,500.00 September 1st, 1966.10,000.00 September 1st, 1967.10,500.00 September 1st, 1968.11,000.00 September 1st, 1969.11,000.00 September 1st, 1970.11,500.00 September 1st, 1971.12,500.00 September 1st, 1972.13,000.00 September 1st, 1973.14,000.00 2400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1968, Tome 86, N° 32 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Maniwaki, Cté Gatineau.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Maniwaki, comté de Gatincau.Lcsdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprUnt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 20 août 1953, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville de Maniwaki, comté de Gatineau.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.' Maniwaki, (Comté de Gatincau), ce 4 août 1953.Le Secrétaire-trésorier, LÉO-PAUL GRONDIN, C.P.59, Hôtel de Ville, Maniwaki, (Cté Gatincau), P.Q.33330-o The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Maniwaki, Co.Gatineau.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or .at Maniwaki, county of Gatineau.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941 subject to be redeemed'by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, August 20, 1953, at 8 o'clock p.m., at Town Hall of Maniwaki, county of Gatineau.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Maniwaki, (County of Gatineau) August 4, 1953.LÉO-PAUL GRONDIN, Secretary-Treasurer.P.O.B.59, Town Hall, Maniwaki, (Co.Gatineau), P.Q.35330 Vente \u2014 Loi de faillite Province de Québec, district de Montréal Cour supérieure, N° 44/1953.\"En faillite\" Dans l'affaire de la faillite de: Joseph Contala, constructeur, Montréal, débiteur et Claude Per-ras, Syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que les immeubles suivants, savoir: Désignation: Un immeuble situé dans le quartier St-Jcan à Montréal, dit district, la construction y érigée sur deux lots de terre désignés sous les numéros quatre-vingt-quinze et quatre-vingt-seize de la subdivision originaire du lot six cent trente-huit (638-95 et 96), aux plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de St-Laurent et portant le numéro civique 6935 de ladite rue de l'Êpée.Sera vendu, en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, pour le district de Montréal, (En faillite) rendu le 28 juillet 1953, à l'enchère publique suivant la loi, pour ladite vente avoir l'effet du décret forcé au terme du code de procédures civiles, au bureau du shérif du district de Montréal, Palais de Justice, Montréal, JEUDI, le DIX SEPTEMBRE 1953, à ONZE heures de l'avant-midi.Conditions: Comptant En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du gouvernement de 23^% conformément à la loi.Pour autres renseignements et cahier des charges, s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 3e jour d'août 1953.^ Le Syndic, Bureau de: CLAUDE PERRAS.Perras & Perras, Syndics, 4, Notre-Dame est, Montréal, P.Q.35315-32-2-0 Sale \u2014 Bankrupcy Act Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, N°.44/1953.\"In Bankruptcy\" In the matter of bankruptcy of: Joseph Contala, Builder, Montreal, Debtor and Claude Perras, Trustee.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immoveables, to wit: Designation: An immoveable situate in the St.John Ward at Montreal, said district, the building thereon erected on two lots of land designated under numbers ninety-five and ninety six of the original subdivision of lot six hundred and thirty-eight (638-95 and 96), on the official plan and in the book of reference of the.parish of St-Laurent and bearing civic number 6935 of the said street de l'Epée.Shall be sold, in virtue of a judgment of die Superior Court, for the district of Montreal, (In Bankruptcy) rendered July 28, 1953, at public auction according to Law, so that the said sale will have the effect of a Sheriff's sale, according to the terms of Civil Procedure, at the Sheriff's Office, of the District of Montreal, Court House, Montreal, THURSDAY, the TENTH day of SEPTEMBER, 1953, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the purchaser shall pay Government rights of 2%% 'n conformity with the Law.For other information and list of*charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this third day of August, 1953.CLAUDE PERRAS, Office of: Trustee.Perras & Perras, Trustees, 4, Notre-Dame Street, East, Montreal, P.Q.35315-32-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 8th, 1953, Vol.85, No.32 2491 Vente par Hcitation Canada, Province de Québec, District de Montreal.Cour Supérieure, N° 321629.AVIS DE LICITATION Avis public est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Montréal, prononcé le 22 juin 1953, dans une cause mue entre Francis Dandavino, garagiste, mécanicien, domicilié et demeurant à Montréal, demandeur; et Marie-Louise Dandavino, épouse contrac-tuellement séparée de biens de Camille Tucci, presseur, avec lequel elle demeure à 2410 rue Chambly, Montréal, et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure; Ida Dandavino, épouse contrac-tuellemcnt séparée de biens de Léo Bresnahan, mécanicien, avec lequel elle demeure à 1030 rue Argylc, en la cité de Verdun, district de Montréal et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure et Louis Dandavino, mécanicien, demeurant à 7335 nie Chateaubriand, en la cité de Montréal, défendeurs; et Michel Dandavino, électricien, demeurant à 6813 rue Saint-Laurent, en la cité de Montréal; Salvatore Dandavino, vendeur, demeurant à 10420 rue Waverley, en la cité de Montréal; Adeline Dandavino, épouse commune en biens de Raphaële Ferri, journalier, avec lequel elle demeure à 7343 rue Berri, en la cité de Montréal et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins de la validité de la procédure; Anina Dandavino, épouse contractuellement séparée de biens de Marcel Guilbault, plombier, avec lequel elle demeure à 3476 rue Désiré, en la cité de Montréal et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure; Marguerite Dandavino, épouse contractuellement séparée de biens de Jacques Tremblay électricien avec lequel elle demeure à 3478 rue Désiré, en la cité de Montréal, et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure, mis en cause, le partage définitif et la licitation des immeubles ci-après désignés, ont été ordonnés, suivant la loi, savoir: Immeuble numéro 1: \"Un emplacement sis rue Saint-André, à Montréal, désigné sous le numéro soixante-et-huit de la subdivision du lot numéro trois cent vingt-cinq (325-68) aux plan et livre de renvoi officiels du village de la Côte Saint-Louis, avec les constructions y érigées et portant les numéros civiques 4516 et 4518 de cette rue, et droit de passage dans les ruelles sises à côté et en arrière de cet emplacement, en commun, avec tous autres y ayant droit.\" Immeuble numéro 2: \"Un emplacement sis à l'angle Nord-est des rues de Castelneau et de Chateaubriand, à Montréal, disigné sous le numéro quatre-vingt-deux de la subdivision du lot numéro quatre cent quatre-vingt-neuf (489-82) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-aux-Récollets, mesurant 25 pieds de largeur par 87 pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise, avec droit de passage dans les ruelles desservant cet emplacement, en commun, avec tous autres y ayant droit, avec les constructions y érigées et portant les numéros civiques 7331, 7333, 7335, 7337 et 7339 de ladite rue de Chateaubriand.\" Sale by Licitation Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.321629.NOTICE OF LICITATION Public notice is hereby given that, by virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Montreal, rendered on June the 22nd 1953 in a case wherein Francis Dandavino, garage keeper, mechanic, domiciled and residing in Montreal, is plaintiff, and Marie-Louise Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Camille Tucci, presser, with whom she is residing at 2410 Chambly Street, Montreal, and the latter to authorize his wife inasmuch as it is necessary for the validity of the proceedings: Ida Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Léo Bresnahan, mechanic, with whom she is residing at 1036 Argyle, in the city of Verdun, district of Montreal ami the latter to authorize his wife inasmuch as it is necessar.î for the validity of the proceedings and Louis Dandavino, mechanic, residing at 7335 Chateaubriand Street, in the city of Montreal, defendants; and Michel Dandavino, electrician, residing at 6813 St.Laurent Street, in the city of Montreal; Salvatore Dandavino, salesman, residing at 10420 Waverley Street, in the city of Montreal; Adeline Dandavino, wife common as to property of Raphaële Ferri, labourer, with whom she is residing at 7343 Berri Street, in the city of Montreal and the latter to authorize his wife for the validity of the proceedings; Anina Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Marcel Guilbault, plumber, with whom she is residing at 3476 Desire Street, in the city of Montreal ami the latter to authorize his wife inasmuch as it is necessary for the validity of the proceedings; Marguerite Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Jacques Tremblay, electrician, with whom she is residing at 3478 Désiré Street, in the city of Montreal, and the latter to authorize his wife inasmuch as it is necessary for the validity of the proceedings, arc mis en cause, the final partition and the licitation of the immoveable properties hereinafter described, have been ordered as follows, according to the law: Immoveable number 1: \"An emplacement situate on St.André Street, in the city of Montreal, designated as number sixty-eight of the subdivision of the lot number three hundred and twenty-five (325-68) on the Official Plan and Book of Reference of the village of Côte St.Louis, with the building thereon erected and bearing civic numbers 4516 and 4518 of said street and right of way in the lanes situate on the side and in rear of the said emplacement, in common, with all others having same right.\" Immovable number 2: \"An emplacement situate on the North-East corner of de Castelneau and de Chateaubriand Streets, in the city of Montreal, designated as number eighty-two of the said subdivision of the lot number hundred and eighty-nine (489-82) on the Official Plan and Book of Reference of the parish of Sault-alix-Recollets.measuring 25 feet in width by 87 feet in depth, English measure, and more or less, with right of way in the lanes connecting with the said emplacement, in common, with all others having same right; with the buildings thereon erected bearing civic numbers 7331, 7333, 7335, 7337 and 7339 of said de Chateaubriand Street.\" 2492 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1958, Tome 85, N° 82 Les immeubles ci-dessus désignés seront mis à l'enchère et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur Je MERCREDI, NEUVIÈME jour de SEPTEMBRE 1953, à DIX heures et DEMIE de l'avant-midi, heure avancée, Cour tenante, dans la salle d'audience de l'ancien palais de justice de Montréal, chambre 31, ou à toute chambre indiquée par cette Cour suivant les circonstances, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges ou liste des charges déposées au greffe du Protonotaire de la Cour supérieure, district de Montréal, et toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de ladite cour au moins douze (12) jours avant le jour fixé comme sudit pour la vente et adjudication et toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six (G) jours après l'adjudication; à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent avis, elle seront forcloses du droit de le faire; Tout enchérisseur devra accompagner son offre ou enchère: a) quant à l'immeuble numéro 1, ci-haut désigné, l'emplacement rue Saint-André, d'une somme de mille cinq cents dollars ($1,500.00); b) quant à l'immeuble numéro 2, ci-haut désigné, l'emplacement angle nord-est des rues De Castelneau et de Chateaubriand, d'une somme de trois mille cinq cents dollars ($3,500.00).Montréal, le 30 juillet 1953.Le Procureur du demandeur, Me HECTOR LALONDE, c.r.266 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal.Harbour 8838.35312-32-2-o The above described immovables will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the WEDNESDAY, the NINTH of SEPTEMBER 1953, at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon, daylight saving time, Sitting the Court, in the Court Room of the Court House of Montreal, room 31, or any other room indicated by the said Court as circumstances permit, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the Superior Court for the District of Montreal, and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation, must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve (12) days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within the six (6) days following the adjudication; and, failing the parties to file the said oppositions within the delays hereby limited, they will be foreclosed from so doing.The offer or bid of every bidder must be accompanied : a) for the immovable number 1, hcrcabove designated as the emplacement on St.André Street, by an amount of one thousand and five hundred dollars (SI ,500.00) ; b) for the immovable number 2, hereabove designated as the emplacement on the North-East corner of de Castelneau and do Chateaubriand Streets, by an amount of three thousand and five hundred dollars ($3,500.00).Montreal, the 30th day of July, 1953.Mr.HECTOR LALONDE, Q.C.Attorney for plaintiff.266 St.James Street West, Montreal, Harbour 8838 35312-32-2-o Vente pour» taxes Sale for Taxes Province de Québec Ville de Bedford Avis public est par le présent donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la ville de Bedford, que conformément à une résolution du Conseil en date du 21 juillet, 1953, l'immeuble ci-dessous mentionné sera vendu à l'enchère publique, au bureau du conseil, à l'Hôtel de Ville, MARDI, le VINGT-CINQ AOÛT prochain (1953), à DLX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêts, plus les frais subséquem-ment encourus à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.Province of Quebec Town of Bedford Public notice is hereby given by the undersigned secretary-treasurer of the town of Bedford, that pursuant to an order of the Council made on July 21, 1953, the immmoveable hereinafter described, will be sold by publuc auction in the office of the Town's Council, at the city Hall, on TUESDAY, the TWENTY-FIFTH dav of the month of AUGUST next (1953) at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the Municipal and School taxes, plus the cost which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and cost be paid before the sale.NOM\tTaxes munie.\tTaxes scol.NAME\tMunie, taxes\tSchool taxes j\t$33.94\tS22.38 Un morceau do terre .mesurant soixante-six pieds de largeur de l'est à l'ouest sur cent quarante-deux pieds de long du nord au sud, le tout plus ou moins, et étant une partie du lot N° mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (Ptie N° 1897) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Stanbridge, dans le comté de Missisquoi.La dite partie étant bornée comme suit: Au Sud, par le chemin public; au Nord, par le terrain de Ernest Procter ou représentants; à l'Est, par partie du même numéro appartenant à Earl C.Johnson ou représentants; et à l'Ouest, par le résidu du môme numéro appartenant à Georges F.Wightman ou représentants.A piece* of land sixty-six feet wide east and west and one hundred and forty-two feet long north and south, more or less and forming part of lot cadastral number one thousand eight hundred and ninety-seven (Part No.1897) upon the official plan and book of reference of the Township of Stanbridge, in the County of Missisquoi.The hereby said piece of land being bounded as follows: South, by the public highway; Nort, by land of Ernest Procter or representatives; East, by part of same number belonging to Earl C.Johnson or representatives; and West, by the residue of same number belonging to Goorgos F.Wightman or representatives. QUEBEC OFFICIA L GAZETTE, Quebec, A ugust 8th, 1958, Vol.S5, No.82 2493 Donné à Bedford, re 24ième jour de juillet, Given at Bedford, this 24th day of July, nine mil neuf cent cinqunntc-trois.teen hundred and fiftv-thrcc.Le Secrétaire-trésorier, EMILE E.DEMERS, 352S7-3l-2-o EMILE-E.DEMERS.35287-31-2-0 Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUHARNOIS Province «le Québec, District de Beauharnois Cour Supérieure./ \"XT ARC LAÇASSE, mar-N°971.< AVlchpd, du Village de V Hcmmingford, district «de Beauharnois, procureur fondé de pouvoirs de Joséphine Laçasse, demandeur; vs WENCESLAS E.PAPINEAU, ci-devant du canton de Hcm-mingford, \" Avec les bâtiments et améliorations dessus.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDft and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUHARNOIS Province of Quebec, District of Beauharnois Superior Court, / \"X KARC LAÇASSE, mer-No.971.< -LVl chant, 0f the village of l Hemmingford, district of Beauharnois, proxy for Josephine Laçasse, plaintiff; vs WENCESLAS E.PAPINEAU, heretofore of the township of Hcmmingford, said district and now of the city and district of Montreal, defendant.NOTICE Public notice is hereby given that the undermentioned lands and tenements have been seized and will be sold at the respective times and places mentioned below: \"A farm situate in the Township of Hcmmingford, county of Huntingdon, known and designated on* the official plan and in the book of reference of the said Township of Hemmingford under lot numbers four B and four D (46 and 4d) fn the first range of the conceded lots of land, with the buildings thereon erected.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St.Romain of Hemmingford, county of Huntingdon, district of Beauharnois.FRIDAY, the ELEVENTH day of SEPTEMBER, 1953, at TEN o'clock in the forenoon, (Daylight Saving Time).HORACE VIAU, Sheriff's Office, Sheriff.Valleyfield, July 20, 1953.35313-32-2 BEDFORD Canada, Province of Quebec District de Bedford.Superior Court, ( f\\UEBEC FARM CREDIT No.4927.W BUREAU, body Jpolitic v and incorporated, having its head office at Quebec, plaintiff, vs ADRIEN TRUDEAU, of Highwater, County Brome, respondent.As belonging to the respondent: A farm property known on the Official Cadastre, for the Township of Potton, Registration Division of Brome, as being: 1.Lot number two hundred and thirty-three (233) containing one hundred and fifteen acres and seventy-eight hundreths of an acre.2.The fifty acres south of lot number two hundred and thirty-seven (Pt.No.237).3.Parts of lots numbers two hundred and thirty-seven and two hundred and forty being all the parts of these lots situate west of the public road crossing the said lots from north to south; Except that part west of the 50 acres and already mentioned.With the buildings and improvements thereon. 2494 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 août 1953, Tome 85, N° 32 Sauf et excepté du lot N° 240 une partie mesurant huit acres en superficie, plus ou moins, vendue à Charles H.Newell par acte devant le notaire soussigné le 17 septembre 1947, dont copie enregistrée sous le N° 6S18G, et à être prise au coin nord-ouest de ce lot.Pour être vendu en bloc, à mon bureau, au Palais de Justice, au village de Sweetsburg, dit district, MERCREDI, le NEUVIÈME jour de SEPTEMBRE, 1953, à DLX heures de l'avant-midi.» Le Shérif, Bureau du Shérif, A.ST-MARTIN.Palais de Justice, Sweetsburg, Que., 3 août 1953.35314-32-2-0 GASPÉ Rimouski, P.Q.Cour Supérieure, / JAMES GORDON RUS-N° 14260
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.