Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 15 août 1953, samedi 15 (no 33)
[" Tome 85, N- 33 2501 Vol.85, No.33 \t \"_ 1\t \t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 15 août 1963 PROVINCE OF QUEBEC Quxbic, Saturday, August 15th, 1953 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1953.Québec, le 8 juin 1953.L'Imprimeur de la Reine.35004-24-12-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'Intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Québec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and-August, 1953.Quebec, this 8th, of June 1953.REDEMPTI PARADIS, 35004-24-12-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office Ottawa, classe, Ministère des Postes Ottawa, Canada.as second class mailable mater.8366 2502 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 86, N° S3 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.G0 Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas.l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc : Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots., Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre: le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième a celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898\u20141-52 the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order ot the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning: but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etot First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions)., Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number: the second to that of the edition of the Gatette for the first insertion: the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u20141-52' Lettres patentes Letters Patent 7155-53) (A.G.7155-53) B.-E.Leclerc & Fils Ltée B.-E.Leclerc & Fils Ltée (P.G.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du deux juillet 1953, constituant en corporation: Barthélémi.-E.Leclerc, marchand, Dame Bar-thélémi-E.Leclerc, femme mariée, Ernest Leclerc, voyageur, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Barthélémi E.Leclerc, merchant, Dame Barthélémi E.Leclerc married woman, Ernest Leclerc, traveler, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Angus, 16th, 1963, Vol.86, No.S3 2503 Faire l'importation, la fabrication et le commerce d'articles de mode, spécialement de chapeaux pour dames, sous le nom de \"B.E.Leclerc, & Fils Ltée\", avec un capital de $125,000, divisé en 1250 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le deux juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14235-53) ^ ^ Besmetal Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, eu date du deux juillet 1953, constituant en corporation: Marcel Emond, industriel, Patrick Walsh, sténographe, Marguerite Proulx, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer des fenêtres et des portes en aluminium, et faire le commerce de l'acier inoxydable, bronze, fer> plastiques, magnésium, et de tous les autres métaux, de leur minerai jusqu'au produit ouvré, sous le nom de \"Besmetal Industries Inc.\", avec un capital de S100,000 divisé en 450 actions communes de $100 chacune, dites actions de classe \"A\", 240 actions privilégiées de classe \"B\" de §100 chacune et 310 actions privilégiées de classe \"C\", de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cap Rouge, rue St-Félix, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le deux juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-Q L.DÉSILETS.(P.G.13342-53) Cancer Aid League Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept juillet 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Dames Ida Tansky, ménagère, épouse séparée de biens de Benjamin Kugelmass, marchand du même lieu, et ledit Benjamin Kugelmass pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Lily Ostroff, ménagère, épouse séparée de biens de Moses Aaron, marchand du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Mary Steinberg, ménagère, épouse séparée de biens de Leo Cohen, gérant du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Toby Hollinger, ménagère, épouse séparée de biens de Jack Levenson, vendeur, du même lieu, et ce dernier pour autoriser sadite épouse aux fins des présentes, Fay Cohen, ménagère, épouse séparée de biens de Hyman Gens-til, gérant du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Martha Pollock, ménagère, épouse séparée de biens de Sydney Nemtin, marchand, du même lieu, et ledit Sydney Nemtin pour autoriser sadite épouse aux fins des présentes, Lillian Cohen, ménagère, épouse séparée de biens de Sydney Shapiro, ingénieur, du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, May Greenblatt, ménagère, épouse séparée de biens To import, manufacture and deal in articles of fashion, especially women's hats, under the name of \"B.E.Leclerc & Fi)s Ltée\", with a capital of §125,000 divided into 1250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.14235-53) Besmetal Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Marcel Emond, industrialist, Patrick Walsh, stenographer, Marguerite Proulx, spinster, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture windows and doors in aluminum, and deal in stainless steel, \"bronze, iron, plastics, magnesium, and in all other metals, of their ore to the wrought product, under the name of \"Besmetal Industries Inc.\", with a capital stock of $100,000 divided into 450 common shares of $100 each, said shares of class \"A\", 240 preferred class \"B\" shares of $100 each, and 310 preferred class \"C\" shares, of $100 each.The head office of the company will be at Cap Rouge, St.Felix Street, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.13342-53) Cancer Aid League Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part in of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1953, incorporating as a corporation without share capirgal: Dame Ida Tansky, housewife, wife separate as to property of Benjamin Kugelmass, merchant, of the same place, and the said Benjamin Kugelmass for the Eurpose of authorizing his wife to these presents, ily Ostroff, housewife, wife separate as to property of Moses Aaron, merchant of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Mary Steinberg, housewife, wife separate as to property of Leo Cohen, manager of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Toby Hollinger, housewife, wife separate as to property of Jack Levenson, sa-lessman, of the same place, and the latter for the purpose of authofizing ljis said wife to these presents, Fay Cohen, housewife, wife separate as to property of Hyman Genstil, manager of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Martha Pollock, housewife, wife separate as to property of Sydney Nemtin, merchant of the same place, and the said Sydney Nemtin for the purpose of authorizing his said wife to these presents, Lillian Cohen, housewife, wife separate as to property of Sydney Shapiro, engineer of the same place, 2.504 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 85, N° 33 de Charles Tanny, marchand du même lieu, et ledit Charles Tanny pour autoriser sadite épouse aux fins des présentes.Ethel Cohen, ménagère, épouse de David Waisberg, manufacturier du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Reva Erdle, ménagè-gère.épouse séparée de biens de Philip Zeesman, gérant de crédit du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux-fins des présentes, Irma Brownstein, ménagère, épouse séparée de biens de Simon (îreenberg.pro])riétaire de taxi du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Alice Zidcl, ménagère, épouse séparée de biens de Harry Morrison, marchand du môme lieu, et ce dernier pour autoriser sadité épouse aux fins des présentes, Lila Herman, ménagère, épouse séparée de biens de William Zuker, gérant du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Edith Erdle, ménagère, épouse 'séparée de biens de Max Schartz, tailleur du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Helen Tomkin, ménagère, épouse séparée de biens de Max Aucrback, dessinateur du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Jean Dankncr, épouse séparée de biens de Abraham Cohen, tailleur du même lieu, et ce dernier pour autoriser sadite épouse aux fins des présentes, Vera Goldman, ménagère, épouse séparée de biens de Edward Von Pragstein, ingénieur, du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Fanny Bassior, ménagère, épouse séparée de biens de Peter Goldncr, gérant du même lieu, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, Belle Beloff, ménagère, épouse séparée de biens de Jack Lu-ber, homme d'affaires du même lieu, et ce dernier pour autoriser sadite épouse aux fins des présentes, toutes des cité et district de Montréal,' pour les objets suivants: Etablir, maintenir et diriger une organisation philanthropique dans la province de Québec aux fins d'assister les hôpitaux, cliniques, médecins et profanes à combattre et traiter la maladie du cancer et les maladies connexes, sous le nom de \"Cancer Aid League Inc.\" Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 850,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juillet 1953.L'Assistant-procureur général.35333 L.DÉSILETS.(A.G.14240-53) Club de Croquet de 1 ici oil Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1953, constituant en corporation: Albert Ducharme, voyageur de commerce, Lucien Lambert, gentilhomme, Edmond Morin, marchand, Edouard Aubry, plombier, Paul Duranleau, avocat et conseil en loi de la Reine, tous de Beloeil, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, May Greenblatt, housewife wife separate as to property of .Charles Tanny, merchant of the same place, and the said Charles Tanny for the purpose of authorizing his\" said wife to these presents, Ethel Cohen, housewife, wife of David Waisbcrg, manufacturer, of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Reva Erdle, housewife, wife separate as to property of Philip Zeesman, credit manager of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Irma Brownstein, housewife, wife Separate as to property of Simon Greenberg.taxi owner of the same place,, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Alice Zidel, housewife, wife separate as to property of Harry Morrison, mer» chant of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his said wife to these presents, Lila Herman, housewife, wife separate as to property of William Zuker, manager of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Edith Erdle, housewife, wife separate as to property of Max Schartz, tailor, of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Helen Tomkin, housewife, wife separate as to property of Max Auerback, designer, of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Jean Dankncr, housewife, wife separate as to property of Abraham Cohen, cutter of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his said wife to these presents, Vera Goldman, housewife, wife separate as to property of Edward Von Fragstcin, engineer, of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his wife to these presents, Fanny Bassior, housewife, wife separate as to property of Pater Goldncr, manager of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his said wife to these presents, Belle Beloff, housewife, wife separate as to property of Jack Luber, businessman of the same place, and the latter for the purpose of authorizing his said wife to these presents, all of the city and district of Montreal, for the following purposes: To establish, maintain and conduct a philanthropic organization throughout the Province of Quebec for the purpose of assisting hospitals, clinics, doctors and laymen in combatting and treating the disease of cancer and related dissea-ses, under the name of \"Cancer Aid League Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is S50.000.* The head office of the Corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(P.G.14245-53) Club de Croquet de Beloeil Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June 1953, incorporating: Albert Ducharmc, commercial traveller, Lucien Lambert, gentleman, Edmond Morin, merchant, Edouard Aubry, plumber, Paul Duranleau, advocate and Queen's Counsel, all of Beloeil, judicial district of Richelieu, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1,053, Vol.35, No.33 2505 Promouvoir et encourager un intérêt dans le sport en général et procurer et entretenir des terrains convenables pour le jeu de croquet et autres exercices, sous le nom de \"Club de Croquet de Belœil Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 400 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Belœil, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général, .35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14245-53) \u2022 Colger Ltd.^ Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq juin 1953 constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat, et conseil en loi de la Reine, de la cité de Westmount, Alan Bernard Gold, avocat, Anne Lash, secrétaire, tous deux de Montréal, et Murray Lapin, avocat, de la ville de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir le terrain connu et désigné comme étant ce certain emplacement vacant ayant front sur le Chemin Côte Saint-Luc, en la cité de Montréal, sous le nom de \"Colger Ltd.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé, en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 2000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dé Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.To promote and encourage an interest in sports generally, and to acquire and maintain suitable grounds for croquet and other physical exercise, under the name of \"Club de Croquet de Beloeil Inc.\".with a capital of $20,000, divided into 400 shares of $50 each.The head office of the company shall be at Beloeil, judicial district of Richelieu.Dated at the7 office of the Attorney General, the twentv-fifth dav of June 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.14245-53) Colger Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearig date the twenty-fifth day of June, 1953, incorporating: Marcus Meyer Sperber, advocate, and Queni's Counsel, of the city of .Westmount, Alan Bernard Gold, advocate, Anne Lash, secretary, both of Montreal, and Murray Lapin, advocate, of the Town of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire the land known and designated as that certain vacant emplacement fronting on Côte St.Luc Road, in the city of Montreal, under the name of \"Colger Ltd.\".The capital stock of the company is divided, into 900 preferred shares of the par value of $100 each, and 2000 common shares without nominal or par value.The head office of the company will be at.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth dav of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(P.G.14290-53) , A.G.14290-53 Continental Automobiles Inc.Continental Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, des lettres patentes en date du Province of Quebec, bearing date the twenty- vingt-deux juin 1953, constituant en corporation: second day of June, 1953, incorporating: W.W.LeM.Owen Carter, avocat, Robert P.Tru- LeM.Owen Carter, advocate, Robert P.Trudel, del, homme d'affaires, tous deux de la cité de businessman, both of the city of Sillery, Peter Sillery, Peter Hessler, administrateur, et Jean Hessler.executive, and Jean Wallis, spinster, Wallis, fille majeure, tous deux de la cité de Que- both of the city of Quebec, all of the, judicial bec, tous du district judiciaire de Québec, pour district of Quebec, for the following purposes: les objets suivants: Négocier et faire le commerce d'automobiles To trade and deal in both old and new motors neuves et usagées, camions, pièces d'automobiles, cars, motor trucks, motor parts, radios, refrige- radios, réfrigérateurs, bicyclettes, motocyclettes rators, bicycles, motorcycles and accessories, et accessoires, sous le nom de \"Continental under the name of \"Continental Automobiles Automobiles Inc.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé .The capital stock of the company is divided en 5,000 actions sans valeur nominale ou au pair into 5,000 shares having no nominal or par value, et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.and into 500 preferrd shares of 8100 each : Le siège social de la compagnie sera à Québec, The head office of the company will be at district judiciaire de Québec.Quebec, judicial district of Quebec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General, deux juin 1953.this twenty-second day of June, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 35333 L.DÉSILETS.35333-o Deputy Attorney General.(P.G.14097-53) Custom Packaging Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- (A.G.14097-53) Custom Packaging Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 2506 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1968, Tome 86, N° 33 vince de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois juin 1953, constituant en corporation: André Gervais, c.a., industriel, de Ville Mont-Royal, André Ducharme, avocat, et Thomas Ducharme, jr., notaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Empaqueter et emballer tous effets et produits de quelque nature que ce soit?sous le nom de \"Custom Packaging Limited\".Le capital-actions de la compagnie est divisé, en 2,000 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social de la compagnie sera au numéro 635, avenue Mitchell, Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14307-53) Cypress Lumber Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1953, constituant en corporation: Jean-H.Deslauriers, avocat, d'Outremont, Ignace-J.Deslauriers, avocat, de Westmount, Yolande Galardeau,'secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce du bois, de ses produits et de ses sous-produits, sous le nom de \"Cypress Lumber Co.Ltd.\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 500 actions sans valeur nominale ou au pair et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Calixte, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14313-53) Dalco Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juillet 1953, constituant en corporation: Shirley Greenshields Dixon, avocat et conseil en loi de la Reine, James Evelyn Mitchell, avocat et conseil en loi de la Reine, Albert Bronson Cul-ver, avocat, Mary Griffiths, comptable, fille majeure, Mary Lennon, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir par achat, vendre et faire le commerce de terrains, bâtisses et autres propriétés réelles ou immobilières, sous le nom de \"Dalco Realties Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.12548-53) Dominion .Television and Appliance Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Province of Quebec, bearing dte the twenty-third day of June 1953, incorporating: André Gervais, C.A., industrialist, of the town of Mount-Royal, André Ducharme, advocate, and Thomas Ducharme, jr., notary, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To pack and wrap up all goods and products of every nature and kind, under the name of \"Custom Packaging Limited\".The capital-stock of the company is divided into 2,000 shares without nominal or par value.The head office of the company shall be at number 635, Mitchell Avenue, Town of Mount-Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third day of June 1953.L.DÉSILETS.35333 Deputy Attorney General.(A.G.14307-53) Cypress Lumber Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, 1953 incorporating: Jean H.Deslauriers, advocate, of Outremont, Ignace J.Deslauriers, advocate of Westmount, Yolande Galardeau, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in wood, its products and by-products, under the name of \"Cypress Lumber Co.Ltd.\", The capital stock of the company is divided into 500 shares of no nominal or par value and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Saint-Calixte, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.14313-53) Dalco Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Shirley Greenshields Dixon, advocate and Queen's Counsel, James Evelyn Mitchell, advocate and Queen's Counsel, Albert Bronson Culver, advocate, Mary Griffiths, accountant, spinster, Mary Lennon, stenographer, spinster, all of the City and judicial dis-, trict of Montreal, for the following purposes: To acquire by purchase, sell and deal in land, buildings and other real or immoveable property, under the name of \"Dalco Realties Limited\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G.12548-53) Dominion Television and Appliance Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1963, Vol.86, No.33 2507 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juillet 1953, constituant en corporation: Arthur F.Garmaise, procureur, de Montréal, Géralde Poupart, secrétaire, de Laval-des-Rapi-des, Paul Tatigian, gérant, de Ville LaSalle, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, manufacturer, vendre et entretenir des appareils de radio, de télévision, d'enregistrement et d'électronique, des appareils de réception, dispositifs, phonographes et accessoires électriques en général, sous le nom de \"Dominion Television and Appliance Company Limited\", avec un capital de $40,000,divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 77 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général,.35333 L.DÉSILETS.(P.G.10344-53) Economie Finance Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juillet 1953, constituant en corporation: Jack Kolodny, marchand, Rae Kalichman, ménagère, épouse séparée de biens de Jack Kolodny, Harry Levine, vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour 1s objets suivants: Agir comme une corporation de finance et de placement, sous le nom de \"Economie Finance Corporation\", avec un capital de $250,000, divisé en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 1500 actions ordnaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux juillet 1953.L'Assistant-procureur général.35333 L.DÉSILETS.(P.G.13564-53) Ferronnerie Robert Hardware Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juillet 1953, constituant en corporation: Gérard Robert, quincaillier, Marie-Paule Robert, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Gérard Robert et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de Rosemont, et Albert Robert, quincaillier, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour lés objets suivants: Faire un commerce général de quincaillerie, meubles, accessoires électriques, sous le nom de \"Ferronnerie Robert Hardware Inc.\", avec un capital de $90,000, divisé en 600 actions privilégiées de $100 chacune et en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept juillet 1953.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July 1953, incorporating: Arthur F.Garmaise, attorney, of Montreal, Géralde Poupart, secretary, of Laval-des-Rapides, Paul Tatigian, manager, of Ville LaSalle, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To buy, manufacture, sell and service radio, television, recording and electronic apparatus, receiving sets, devices, phonographs and electrical appliances generally, under the name of \"Dominion Television and Appliance Company Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 77 St.Catherine St.W., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of July 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.10344-53) Economic Finance Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Jack Kolodny, merchant, Rae Kalichman, housewife, wife separate as to property of Jack Kolodny, Harry Levine, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the follwing purposes: To act as a finance and investment corportion, under the name of \"Economic Finance Corporation\", with a caoital stock of $250,000.00 divided into 1,000 preferred shares of a par value of $100 each and 1500 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G.13564-53).Ferronnerie Robert Hardware Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1953, incorporating: Gérard Robert, hardware merchant, Marie-Paule Robert, housewife, wife separate as to property by marriage contract of said Gérard Robert and duly authorized by the latter for the purposes of these presents, both of Rosemount, and Albert Robert, hardware dealer, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on and deal generally in hardware, furniture, electrical cppliances, under the name of \"Ferronnerie Robert Hardware Inc.\", with a capital stock of $90,000, divided into 600 preferred shares of $100 each and into 300 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS. 2508 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 mût 1963, Tome 86, N° S3 (P.G.15233-53) Formcraft Fabrics Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six juillet 1953, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi de la Reine, de la cité de Westmount, Théodore H.Shapiro, avocat, de Ville Mont-Royal, Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à carder, filer, tisser, tricoter, préparer, teindre, finir, manufacturer et autrement faire le négoce de soie, coton, jute, laine, rayon et autres substances fibreuses, fils; étoffes et tissus, sous le nom de \"Formcraft Fabrics Co.Limited\", avec un capital de $50,000, divisé en 250 actions ordnaires de $100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.13387-53) Goldmark Optical Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juillet 1953, constituant en corporation: John Cerini, c.r.procureur, Ethel Fisk, secrétaire, épouse séparée de corps et de biens, de Noel Davies, tous deux de Montréal, Robert Learmont Jamieson, procureur, de Pointe-Claire, Marie-Claire Kirkdland, procureur, fille majeure, de-Ville St-Pierre, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général d'accessoires d'optique et fabriquer le verre en lentilles de toutes sortes, sous le nom de \"Goldmark Optical Supplies Ltd.\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.14456-53) H.-L.Singer Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juillet 1953, constituant en corporation: George Whelan, avocat, de la ville de Pointe aux Trembles, James Topping, John Di Massino, tous deux surintendants, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de soieries, satins, cotonnades, lainages, tissus et vêtements de toutes sortes; faire le commerce de tous matériaux, appliques, accessoires et articles utilisés pour l'exécution des opérations dudit commerce, sous le nom de \"H.L.Singer Co.\", avec un capital de $75,000 divisé en 1,000 actions ordinaires et 6500 actions privilégiées, toutes d'une valeur au pair de $10 chacune.(A.G.15233-53) Formcraft Fabrics Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of July, 1953, incorporating: Benhamin Robinson, advocate and Queen's Counsel, of the city of Westmount, Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, Ethel Yussem, secretary, spinster, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of carding, spinning, weaving, knitting, preparing, dyeing, finishing, manufacturing and otherwise dealing in silk, cotton, jute, wool, rayon and other fibrous substances, threads, cloths, fabrics, under the name of \"Formcraft Fabrics Co.Limited\", with a capital stock of $50,000.divided into 250 common shares of $100 each, and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.13387-53) Goldmark Optical Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating: John Cerini, Q.C.barrister, Ethel Fisk, secretary, wife separate as to bed and board of Noel Davies, both of Montreal, Robert Learmont Jamieson, barrister, of Pointe-Claire, Marie-Claire Kirkland, barrister, spinster, of Ville St.Pierre, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the general business of optical supplies and manufacturers of glass into lenses of all kinds, under the name of \"Goldmark Optical Supplies Ltd.\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.14456-53) H.-L.Singer Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating: George Whelan, advocate, of the Town of Pointe aux Trembles, James Topping, John Di Massino, both superintendents, of the City of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of silks, satins, cottons, woollens, fabrics and wearing apparel of every kind; to deal in all materials, fixtures, supplies and articles used in the said business operations, under the name of \"H.L.Singer Co.\", with a capital stock of $75,000.divided into 1,000 common shares and 6500 preferred shares all of a par value of $10.each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1953, Vol.85, No.38 2509 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.14440-53) Industrial Accessories Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-t ie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente juin 1953, constituant en corporation: Albert Edward Sawyer, gérant, Robert Barclay Ritchie, comptable, tous deux de la cité de Montréal, Frederick George Payne, ingénieur de ventes, de la ville de Côte St-Luc, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer, faire le négoce comme marchands en gros, détaillants et agents de machinerie, de toutes sortes, de bouilloires, unités de pouvoir, installations électriques, minières, hydrauliques et industrielles, machines-outils et étampages, instruments de précision, articles en caoutchouc, quincaillerie et briques à feu, sous le nom de \"Indus-trial Accessories Ltd.\", avec un capital de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.14131-53) John Brooks & Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-trois juin, 1953, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, Charles Eric Humphrey, comptable, et Alexander Gordon Yeomen, commis en loi, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Vendre et exercer le commerce de tous produits de l'agriculture, de la forêt, de carrière, des mines et puits, des mers, lacs, bétail vivant et mort et des produits dérivés; quincaillerie, vaisselle, marchandises électriques, sous le nom de \"John Brooks & Company Limited\", avec un capital de $20,000, divisé en 2,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-troisième jour de juin, 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 ' .L.DÉSILETS.(P.G.14359-53) J.-P.Morin Ltde Avis est donné qu'en vertu de la première partie, de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf juin 1953, constituant en corporation: David Belhumeur, C.A., Jeannette Ga-mache, sténographe, Gaston Bellerive, comptable, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.14440-53) Industrial Accessories Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of June, 1953, incorporating: Albert Edward Sawyer, manager, Robert Barclay Ritchie, accountant, both of the city of Montreal, Frederick George Payne, sales engineer, of the town of Côte St.Luc, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing, dealing with as wholesalers, retailers, agents in machinery of all kinds, boilers, power plant electrical, mining, hydraulic and industrial equipment, machine tools and stampings, precision instruments, rubber goods, hardware, fire bricks, under the name of \"Industrial Accessories Ltd.\", with a capital stock of $10,000, divided into 100 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.14131-53) John Brooks & Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of June, 1953, incorporating: Ernest William Mockridgc, manager, Charles Eric Humphrey, bookkeeper, and Alexander Gordon Yeomen, law clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To sell and deal in and with all products of agriculture, the forest, quarry, mine and well, the seas, lakes, live stock and dead stock and the products thereof; hardware, china, electrical goods, under the name of \"John Brooks & Company Limited\", with a capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at.the office of the Attorney General, this twenty-third day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G.14359-53) J.-P.Morin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1953, incorporating: David Belhumeur, C.A., Jeannette Gamache.stenographer, Gaston Bellerive.accountant, all of the city and judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: \u2022 2510 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1963, Tome 85, N° 33 Agir comme entrepreneur en construction tous le nom de \"J.P.Morin Ltée\", avec un capital de §150,000 divisé en 800 actions ordinaires de §100 chacune et en 700 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 528, rue Notre-Dame, Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivièrcs.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14270-53) Labrador Ungava Explorations Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies munières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-trois juin 1953, constituant en corporation: John Bumbray, conseil en loi de la Reine, de Ville Mont-Royal, Jean Paul Cardinal, Marcel Lajeunesse, avocats, Anna Mikula, Thérèse Boisay, secrétaires, filles majeures, tous quatre de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Labrador Ungava Explorations Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital de $4,000,000 divisé en 4,000, 000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.13472-53) La Ligue des Propriétaires du quartier Saint-Jean-Baptiste de Saint-Joseph de Sorel Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente juin 1953, constituant en corporation sans capital-actions: André Gué-rard, entrepreneur, Noël Cormier, J.-Léo For-tier, comptables, Marcel Munger.André Foricer, commis, Jean-Arthur Deschenes, Oscar Bessette, contremaîtres, et Aurèle Racine, inspecteur, tous de Saint-Joseph de Sorel, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Grouper les propriétaires du quartier Saint-Jean Baptiste afin de mieux se connaître et s'entraîder.sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires et Quartier St-Jean Baptiste de St-Joseph de Sorel\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est $5,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Joseph de Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le trente juin 1953.To carry on building contractor under the name of \"J.P.Morin Ltée\", with a capital stock of $150,000 divided into 800 common shares of $100 each and into 700 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 528 Notre-Dame Street, Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June, 1953.L.DÉSILETS.35333 Deputy Attorney General.(A.G.14276-53) Labrador Ungava Explorations Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of June, 1953, incorporating: John Bumbray, Queen's Counsellor, of the Town of Mount Royal, Jean-Paul Cardinal, Marcel Lajeunesse, advocates, Anna Mikula, Thérèse Boisay, secretaries, spinsters, all four of Montreal, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"La-brakor Ungava Explorations Ltd.\" (No Personal Liability), with a capital stock of $4.000,000.divided into 4,000,000 shares of $1.each.The shareholders incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third*day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G-.13472-53) La Ligue des Propriétaires du quartier Saint-Jean-Baptiste de Saint-Joseph de Sorel Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of June, 1953, incorporating without share capital: André Guérard, contractor, Noël Cormier, J.Léo Fortier, accountants.Marcel Munger, André Foricer, clerk, Jean-Arthur Deschenes, Oscar Bessette, foremen, and Aurèle Racine, inspector, all of Saint-Joseph of Sorel, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To group together the proprietors of the Saint-John Baptist Ward so as to become better acquainted and to help each other, under the name of \"La Ligue des Propriétaires du Quartier St-Jean Baptiste de St-Joseph de Sorel\".The amount to which the immoveable property which the corporation may possess is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation will be at Saint-Joseph of Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 196S, Vol.85, No.88 2511 (P.G.14385-53) La Maison Dominion Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-neuvième jour de juin, 1953, constituant en corporation : lien Ahramspn, marchand, Dorothy Abramson, épouse séparée de biens dudit Hen Abramson, dûment authorise par son dit mari, Isaac Abramson, Abraham Gershuni, marchands, tous .de la cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et vendre ou autrement faire le commerce ou le négoce de laine, coton, tissus, soie et vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"La Maison Dominion Ltée\", avec un capital de $100,000 divisé en -2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et en 8,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la corporation sera à 30 rue St-.Ioseph, en la cité et district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuvième jour de juin, 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(A.G.14385-53) La Maison Dominion Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1953, incorporating' Hen Abramson, merchant, Dorothy Abramson, wife separate as to property of the said Ben Abramson, duly authorized by her said husband, Isaac Abramson, Abraham Gershuni, merchants, all of the City and judicial district of Quebec, for the following puiposes: To manufacture and sell or otherwise deal in or with wool, cotton, fabrics, silks and clothing of every sort, under the name of \"La Maison Dominion Ltée\", with a capital stock of $100,000 divided into 2,000 common shares at a par value of $10.each, and 8,000 preferred shares at a par value of $10.each.The head office of the Company will be at 39 St.Joseph, in the city and judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(P.G.13326-53) Les Constructions Saint-Jean Limitée \"St.Johns Constructions Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juillet 1953, constituant en corporation: Réal Désourdy, Normand Désourdy, contrac-teurs, de Venise-en-Québec, Robert Archambault, comptable, de Henryville, tous du district judiciaire d'Bjerville, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et de construction de tous genres, sous le nom de \"Les Constructions Saint-Jean Limitée\" \u2014 \"St.John's Constructions -Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Saint-Jean, district judiciaire d'Iherville.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(A.G.13326-53) Les Constructions Saint-Jean Limitée St.Johns Constructions Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating: Réal Désourdy, Normand Désourdy, contractors, of Venise-en-Québec, Robert Archambault, accountant, of Henryville, all of the judicial district of Iberville, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and to deal in all kinds of construction, under the name of \"Les Constructions Saint-Jean Limitée\" \u2014 \"St.John's Constructions Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be in the city of Saint-John's judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this third day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(P.G.11973-53) Metropolitan Factors Corporation Avis est donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juillet 1953, constituant en corporation: Michael Garber, avocat, et conseil en loi de la Reine, de la cité de Westmount, Jacob Harold Blumenstein, avocat, Jacob Margulis,-'marchand, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de finance et de prêts, sous le nom de.\"Metropolitan Factors Corporation\", avec un capital de $225,000, divisé en 1800 actions ordinaires de $50 chacune et 2700 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.11973-53) Metropolitan Factors Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Compares' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Michael' Garber, advocate and Queen's Counsel, of the city of Westmount, Jacob Harold Blumenstein, advocate, Jacob Margulis, merchant, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as finance and loan corporation, under the name of \"Metropolitan Factors Corporation\", with a capital stock of $225,000, divided into 1800 common shares of $50.each and 2700 preferred shares of $50.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 2512 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 86, N° 33 Daté du bureau du Procureur général, le deux Dated at the office of the Attorney General, juillet 1953.this second day of July, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DESILETS, 35333 L.DÉSILETS.35333-o Deputy Attorney General.(P.G.14325-53) Millcrev Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept juin 1953, constituant en corporation: David Goodman, avocat, de la cité de Hampstead Jack Lightstone, avocat, Imelda Langlois, commis, fille majeure, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir et posséder une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Millcrev Holdings Ltd.\", avec un capital de S20.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept juin 1053.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.12087-53) Modern Finance Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première-partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit juillet 1953, constituant en corporation: Nicholas B.Yared, manufacturier, de Montréal, James Saad, Wilfrid Howick, manufacturiers, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général d'agent de finance; manufacturer, acheter, vendre dès voitures automobiles et toutes sortes de véhicules, sous le nom de \"Modem Finance Company Limited\", avec un capital de $225,000, divisé en 2250 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.12843-53) National Auto Body Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du sept juillet 1953, constituant en corporation: John Turner, gérant, Isabella Gorrie, ménagère, Joseph Antonio Mérineau, surintendant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et, en général, faire le commerce de toutes sortes d'automobiles, moteurs et toutes sortes de machinerie; exploiter des garages, sous le nom de \"National Auto Body Co.Ltd.\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juillet 1953.(A.G.14325-53) Millcrev Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, 1953, incorporating: David Goodman, advocate, of the city of Hampstead, Jack Lightstone, advocate, Imelda Langlois, clerk, spinster, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the-following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold and own a certain immoveable property, under the name of \"Millcrev Holdings Ltd.\", with a capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o 1 Deputy Attorney General.(A.G.12087-53) Modern Finance Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of July, 1953, incorporating: Nicholas B.Yared, manufacturer, of Montreal, James Saad, Wilfrid Howick, manufacturers, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business generally as a financial agent; to manufacture, to buy, sell motor cars and all kinds of véhicules, under the name of \"Moderne Finance Company Limited\", with a capital stock of $225,000, divided into 2250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.12843-53) National Auto Body Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1953, incorporating: John Turner, manager, Isabella Gorris, housewife, Joseph Antonio Mérineau, superintendent, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in all kinds of automobile, motors, and a(l kind of machinery; to operate garages, under the name of \"National Auto Body Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of$100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August lôth, 1963, Vol 85, No.33 2513 (P.G.14273-53) National Beef Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juillet 1953, constituant en corporation: Hyman Cari Goldenberg, avocat et conseil en loi de la Reine, Moses Samuel Yelin, avocat, Lillian Winch, Esther Monson, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Importer, exporter, acheter, vendre ou autrement faire le négoce ou le commerce de toutes sortes de produits animalesques, produits végétaux, produits minéraux, ainsi que leurs sous-produits, sous le nom de \"National Beef Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.14460-53) National Boiler Works Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit juillet 1953, constituant en corporation: Charles*-Edouard Bertrand, Roland-Gérard Le-françois, avocat, Denise Bastien, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire commerce de toutes sortes de bouilloires, de fournaises, de systèmes de chauffage et d'appareils de réfrigération, de ventilation et de climatisation de l'air, sous le nom de \"National Boiler Works Co.Ltd.\", avec un capital de $100, 000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14472-53) Paris Canada Films (Quebec) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québgp des lettres patentes, en date du six juillet 1953, constituant en corporation: Georges Arpin, gérant, Jean-Paul Verschelden, Maurice-D.Godbout, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Fabriquer, acheter, vendre, louer, projeter et répandre des films cinématographiques de tous genres, appareils de reproduction de son, sous le nom de \"Paris Canada Films (Quebec ) Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de, Montréal.Daté du bureau du Prolureur général le six juillet 1953.(A.G.14273-53) National Beef Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating: Hyman Carl Goldenberg, advocate and Queen's Counsel, Moses Samuel Yelin, advocate, Lillian Winch, Esther Monson, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To import, export, buy, sell or otherwise deal in or with all animal products, vegetable products, mineral products, as well as the by-products thereof, under the name of \"National Beef Inc.\", with a capital stock of 8100,000.divided into 500 common shares of the par value of $100.each, and 500 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G.14460-53) National Boiler Works Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of July, 1953, incorporating: Charles-Edouard Bertrand, Roland-Gérard Lefrançois, advocate, Denise Bastien, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of boilers, furnaces, heating and refrigeration, ventilation and air-conditioning systems, under the name of \"National Boiler Works Co.Ltd.\", with a capital stock of $100,000 divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.14472-53) Paris Canada Films (Quebec) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of July, 1953, incorporating: Georges Arpin, manager, Jean-Paul Verschelden, Maurice D.Godbout, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy, sell, rent, project and circulate cinematographic films of all kinds, appliances of sound reproduction, under the name of \"Paris Canada Films (Quebec) Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général, 35333-0 \u2022 L.DÉSILETS. 2514 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 85, N° 33 (P.G.13388-53) Phil Himes Mfg.Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du trois juillet 1953, constituant en corporation: Blanka Gyulai, tencuse de livres, veuve, Raymon-de Doyle, secrétaire, fille majeure, Harry Blank, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le négoce ou le commerce de vêtements de toute nature et description, sous le nom de \"Phil Himes Mfg.Inc.\", avec un capital de $100,000, divisé en 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à MontrénL district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.- \u2022 L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(A.G.13388-53) Phil Himes Mfg.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating: Blanka Gyulai, bookkeeper, widow, Raymondc Doyle, secretary, spinster, Harry Blank, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with clothing of every nature and description, under the name of \"Phil Himes Mfg.Inc.\", with a capital stock of $100,000, divided into 750 preferred shares having a par value of $100 each, and 250 common shares having a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(P.G.13497-53) Scandia Supply Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du septième jour de juillet, 1953, constituant en corporation: Arthur P.Garmaise, Clarence Rosenhek, avocats, et Georgia M.Smith, célibataire, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre le commerce d'agents de manufacturiers et distributeurs de fournitures techniques pour des installations et machinerie de toutes sortes, servant à l'industrie, sous le nom de \"Scandia Supply Co.Ltd.\", avec un capital action de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le septième jour de juillet, 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.13343-53) Société Zoologique de Granby Inc.» Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juillet 1953, constituant en corporation sans capital-actions: J.-Ambroise Comeau, marchand, Achille Rousseau, directeur des études, Noël Brosseau, vétérinaire, tous de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Administrer le jardin zoologique de Granby, voir à son entretien et son amélioration, sous le nom de \"Société Zoologique de Granby Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le sept juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(A.G.13497-53) Scandia Supply Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1953, incorporating: Arthur P.Garmaise, Clarence Rosenhek, advocates, and Georgia M.Smith, spinster, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes : To engage in the business of manufacturer's agents and distributors of technical supplies for industries equipment and machinery of all kinds, under the name of \"Scandia Supply Co.Ltd.\", with a capital stock of $20,000, divided into 200 shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.13343-53) Société Zoologique de Granby Inc.Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1953, incorporating without share capital: J.-Ambroise Comeau, merchant, Achille Rousseau, director of studies, Noël Brosseau, veterinary, all of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To manage the zoological garden of Granby, see to its maintenance and its improvement, under the name of \"Société Zoologique de Granby Inc.\".The amount to which the immoveable property which the corporation may possess is limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Augus 16th, 1968, Vol.85, No.83 2515 (P.G.14242-53) Staplecraft Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juillet 1953, constituant en corporation: Guy Gagné, comptable, de la cité de ltosemont, Joseph Gérald Mahoney, agent de manufacturiers et Mary McJannet, secrétaire, épouse commune en biens dudit Joseph Gérald Mahoney, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes d'installations de brochage industriel, mécaniques et manuelles, ainsi que leurs accessoires, comprenant des broches recouvertes et clous, installations de toutes sortes pour le brochage au fil de fer et liens en acier; accessoires et fournitures de bureaux, sous le nom de \"Staplecraft Company Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.14451-53) St.Michael's Dry Cleaners Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du deuxième jour de juillet, 1953, constituant en \"corporation: Paul Galt Michaud, Maurice Mercier, avocats, Thérèse Servant, sténographe, célibataire, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général de teinturerie, nettoyage, pressage et réparation; exploiter un commerce-général de buanderie, sous le nom de \"St.Michael's Dry Cleaners Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le deuxième jour de juillet, 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.14129-53) Stork Shops Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six juillet 1953, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, de Montréal, Cyril E.Schwis-berg, avocat, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands d'habits, vêtements, chaussures, jouets d'enfants et objets pour le jeu, sous le nom de \"Stork Shops Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1107 Boulevard Décarie, Ville St-Laurent, district (A.G.14242-53) Staplecraft Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Guy Gagné, accountant, of the city of Rosemont, Joseph Gérald Mahoney, manufacturer's agent, and Mary McJannet, secretary, wife common as to property of the said Joseph Gérald Mahoney, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of industrial stapling equipment, both power and manual, as well as supplies including covered staples and nails, wire stitching equipment of all kinds, steel strapping; office supplies and equipment, under the name of \"Staplecraft Company Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each, and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.14451-53) St.Michael's Dry Cleaners Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1953, incorporating: Paul Gait Michaud, Maurice Mercier, advocates, Thérèse Servant, stenographer, spinster, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general dyeing, cleaning, pressing and repairing business; to carry on a general laundry business, under the name of \"St.Michael's Dry Cleaners Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 5,000 common shares at a par vzlue of $1.each, and 350 preferred shares at a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G.14129-53) Stork Shops Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of July, 1953, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, secretary, fille majeure, of Montreal, Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outremont, all of the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers in clothing, wearing apparel, shoes, kiddies toys ank playthings, under the name of \"Stork Shops Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares or $100 each., The head office of the Company will be at 1107 Decarie Blvd., Ville St.Laurent, judicial 2516 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 86, N° 33 judiciaire de Montreal.district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le six Dated at the office of the Attorney General juillet 1953.this sixth day of July, 1953.L'Assistant-procureur général, L.DESILETS, 35333 L.DÉSILETS.35333-o Deputy Attorney General.(P.G.14459-53) Valois Youth Recreational Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juillet 1953.constituant en corporation sans capital-actions: Lucien Leblanc.Kenneth Bolger, tous deux gérants de ventes, Walter Devereux, chef électricien, Archibald Brown Grassie, administrateur.William McClurg, commis de prix de revient, Edwin Victor Burgess, gérant de circulation, Leslie Sherwood Watier, gérant de bureau, Thomas Osborne Davis, administrateur du téléphone, Harold Wittaker, agent d'assurances, Alexander Janusit is, officier de relations publiques, tous de Valois, en la ville de Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir, organiser et surveiller les facilités et activités sociales et récréatives au bénéfice de la localité communément connue sous le nom de Valois, en la ville de Pointe-Claire, et, principalement, au bénéfice de la jeunesse de cette localité, sous le nom de \"Valois Youth Recreational Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation sera en la ville de Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.13369-53) Wasacz Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente juin 1953, constituant en corporation: Michael Wasacz, entrepreneur, Ted Franczyszyn, commis au prix de revient, tous deux de la cité de Montréal, et Armand Hildège Vian, comptable, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux pour la construction et l'aménagement de bâtisses, sous le nom de \"Wasacz Construction Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de'8100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 ^ L.DÉSILETS.(P.G.14455-53) Wilfrid Lévesque Incorporé (A.G.14459-53) Valois Youth Recreational Association Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of July, 1953, incorporating as a corporation without share capital: Lucien Leblanc, Kenneth Bulger, both sales .managers, Walter Devereux, chief electrician, Archibald Brown Grassie, executive, William McClurg, cost clerk, Edwin Victor Burgess, traffic manager, Leslie Sherwood Watier, office manager, Thomas Osborne Davis, telephone executive, Harold Wittaker, insurance agent, Alexander Janusitis, public relations officer, all of Valois, in the town of Pointe Claire, judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote, organize ami supervise social and recreational facilities and activities for the benefit of the community commonly known as Valois in the town of Pointe Claire and primarily for the benefit of the youth of such community, under the name of \"Valois Youth Recreational Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited is 8100,000.The head office of the corporation will be at the town of Pointe Claire, in the judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.13369-53) Wasacz Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of June, 1953, incorporating: Michael Wasacz contractor, Ted Francsyszyn, cost clerk, both of the city of Montreal, and Armand-Hildègc Viau, accountant, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors for the construction and equipment of buildings, under the name of \"Wasacz Construction Co.Ltd.\", with a capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of 8100 each, and 300 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.(A.G.14455-53) Wilfrid Lévesque Incorporé Avis est donné qu'en vertu de là première Notice is hereby given that under Part J, of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1958, Vol.85, No.38 2517 province de Quebec des lettres patentes, en date tlu huit juil'et 1953, constituant en corporation: Wilfrid Lévesque, agent, Einilien lévesque, mécanicien, Gérard Sénécal, comptable, tous de Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski, poulies objets suivants: Faire le commerce de véhicules-moteurs, tracteurs, machines aratoires; exploiter un garage, sous le nom de \"Wilfrid Lévesque Incorporé\", avec un capital de §50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le, siège social de la compagnie sera à Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le huit juillet 1953.L'Assistant-prolureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(A.G.14248-53) Windsor Dress Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin, 1953, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Briskin, advocats, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de robes, costumes, manteaux et vêtements de description quelconque, sous le nom de \"Windsor Dress Co.Ltd.\", avec un capital de $85,000, divisé en 450 actions privilégiées de $100 chacune et en 400 actions ordinaires de-$100 chacune.Le siège socjal de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.Province of Quebec, bearing date the eighth day of July.1953, incorporating: Wilfrid Lévesque, agent, Emilicn Lévesque.mechanic, Gérard Sénécal.accountant, all of Mont-Joli, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To deal in motor vehicles, tractors, farm implements; to operate a garage, under the name of \"Wilfrid Lévesque Incorporé\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 I'LU'll.The head office of the company will be at Mont-Joli, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.14248-53) Windsor Dress Co.Ltd.\u2022Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty fifth day of June, 1953, incorporating: Max Liverman.Leonard Liverman, Julius Brisking advocates, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dresses, suits, coats and apparel of any description whatsoever, under the name of \"Windsor Dress Co.Ltd.\", with a capital stock of $85,000.divided into 450 preferred shares of $100.each and 400 common shares of S100.each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth dav of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.14466-53) F.-J.Raskin Incorporée Avis est donné xu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du deux juillet 1953, à la compagnie \"F.-J.Raskin Incorporée\", subdivisant ses 150 actions ordinaires de $100 chacune en 15,000 actions ordinaires de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 2 juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.16067-53) Food Products Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 16 juillet 1953, changeant le nom de la compagnie \"Food Colours Ltd.\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes en date du 26 mai 1934, et par lettres patentes supplémentaires datées du 27 novembre 1952, en celui de \"Food Products Limited\".Supplementary Letters Patent (A.G.14466-53) F.-J.Raskin Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the second day of July, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"F.-J.Raskin Incorporée\", subdividing its 150 common shares of 8100'each into 15,000 common shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this 2nd dav of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.16067-53) - Food Products Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letterd patent, bearing date the 16th day of July, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"Food Colours Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated May 26, 1934, and by supplementary letters patent dated November 27, 1952, to \"that of \"Food Products Limited\". 2518 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1.953, Tome 85, N° 33 Daté du bureau du Procureur général, le 10 juillet 1953.1/Assistant \u2022procureur général.35333 L.DÉSILETS.(P.G.16034-53) International Plumbing and Heating » Supplies Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a é,fé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 17 juillet 1953, à la compagnie \"International Plumbing and Heating Suppliés Limited\", augmentant son capital de 8100,000 à $249,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1490 actions ordinaires de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 17 juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.(P.G.15237-53) Lord & Cie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province vie Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze juillet 1953, à la compagnie \"Lord & Cie Limitée\", augmentant son capital de 819.S00 à 869,800: le capital-actions additionnel étant divisé en 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 15 juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.7161-53) Peel Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 30 juin 1953, à la compagnie \"Peel Investment Corporation\", convertissant et subdivisant 490 actions privilégiées de 8100 chacune en 49,000 actions ordinaires de SI chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 30 juin 1953.# L'Assistant-procureur général, 35333 I'.DÉSILETS.(P.G.15814-53) Salon Astrid Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes, supplémentaires, en date du seize juillet 1953, à la compagnie \"Salon Astrid Limitée\", augmentant son capital de $99,000 à $1*0,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 510 actions privilégiées de $100 chacune, et modifiant les dispositions des lettres.patentes originaires de ladite compagnie.Daté du bureau du Procureur général le 16 juillet 1953.Dated at the office of the Attorney General the 16th dav of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.16034-53) International Plumbing and Heating Supplies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of July.1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"International Plumbing and Heating Supplies Limited\", increasing its capital from 8100,000 to 8249,000: the additional capital stock being divided into 1490 common shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, the 17th dav of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-0 Deputy Attorney General.A.G.15237-53) Lord & Cie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the fifteenth day of July, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, tothecom-pany, \"Lord & Cie Limitée\", increasing its capital from $19.800 to 869,800: the additional capital stock being divided into 500 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, this 15th dav of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.7161-53) Peel Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of June, 1053, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec to the company \"Peel Investment Corporation\", converting and subdividing 190 preferred shares of $100 each into 49,000 common shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General the 30th dav of June, 1953.L.DÉSILETS.35333-o Deputy Attorney General.(A.G.15814-53) Salon Astrid Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the sixteenth day of July, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with, section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company: \"Salon Astrid Limitée\"^ increasing its capital stock from 899,000 to $150,000: the additional capital stock being divided into 510 preferred shares of $100 each, and amending the provisions of the original letters patent of said company.Dated at the office of the Attorney General, this 16th dav of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général.35333-e .L.DÉSILETS. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1053, Vol.35, No.33 2519 (P.G.14396-53) Stanley Hugg Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première particule la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 30 juin 1953, à la compagnie \"Stanley Bagg Corporation\", augmentant son capital-actions de 208,000 actions privilégiées «le $5 chacune, et fixant à $234,000 le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations.Daté du bureau du Procureur général, le 30 juin 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÊSIFETS.(P.G.14383-53) The Call way Sash and Door Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 2 juillet 1953, à la compagnie \"The Callway Sash and Door Incorporated\", augmentant son capital de $4,000 à $79.000; le capital-actions additonnel étant divisé en 750 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général le 2 juillet 1953.L'Assistant-procureur général.35333-0 L.DÉSILETS.(P.G.14465-53) Tilden Rent-A-Car Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LuRichc-lière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q., 1941, chpitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 2 juillet 1953, changeant le nom de la compagnie \"Tilden Drive Yourself Company\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes datées du 13 février 1928.en celui de \"Tilden Rcnt-A-Car Company\".Daté du bureau du Procureur général, le 2 juillet 1953.L'Assistant-procureur général, 35333 L.DÉSILETS.Action en séparation de biens AVIS Canada, Province de Québec, district de Beau-ce, ('our Supérieure, N° 23,113.Dame Geor-gianna Poulin, ménagère de Notre Dame de la Providence, Cté Beauce, épouse commune en biens de Philippe Rodrigue, rentier anciennement de Notre-Dzme de la Providence et actuellement résidant à St-Côme, Cté Beauce, a formé contre son mari une action en séparation de biens.St-Joseph-de-Beauce, 11 août 1953.Le Procureur de la demanderesse, 35367-u ANT.LACOURCIERE.C.R.(A.G.14396-53) Stanley Bagg Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of June, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the'Province of Quebec, to the company \"Stanley Bagg Corporation\", increasing its capital stock by 208.000 preferred shares of 85 each, and fixing at 8234.000 the amount with which the company shall continue its operations.Dated at the office of the Attorney General, this 30th day of June, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.(A.G.14383-53) The Callway Sash and Door Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated July, second, 1953, to the company \"The Callway Sash and Door Incorporated\", increasing its capital stock from 84.000 to S70.000: the additional capital stock being divided into 750 preferred shares of 8100.Dated at the office of the Attorney General, this 2nd day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333 Deputy Attorney General.(A.G.14465-53) Tilden Rent-A-Car Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the 2nd day of July, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, changing the name of the company \"Tilden Drive Yourself Company\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated February 13th, 1928, to that of \"Tilden Rent-A-( !ar Company\".Dated at the office of the Attorney General, the 2nd day of July, 1953.L.DÉSILETS, 35333-o Deputy Attorney General.Action for separation as to property NOTICE Canada, Province of Quebec, district of Beauce, in the Superior Court, No.23,113.Dame Gcorgianna Poulin, housekeeper of Notre Dame de la Providence, Co.Beauce, wife common as to property of Philippe Rodrigue, rentier anciently of Notre Dame de la Providence and now living at St.Come, Co.Beauce, has taken an action against her husband for separation as to property.St.Joseph of Beauce, August 1 lt.li, 1953.ANT.LACOURSIERE.C.R., 35367-Q * Attorney for plaintiff. 2520 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 86, N° 33 Arrêté en Conseil ARRÊTE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF Numéro 910 Québec, le 6 août 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouvcrncur-en-Conscil.Concernant certains actes administratifs du Secrétariat de la Province.Concernant l'abrogation du règlement numéro 15 de la Commission des accidents du travail de Québec et son remplacement par le règlement numéro 19 de la dite Commission.Attendu que la Commission des accidents du travail de Québec, lors de la réunion de ses commissaires tenue le 1er juin 1953, a adopté une résolution à l'effet «l'abroger son règlement portant le numéro 15, adopté le 30 juillet 1942 et approuvé par l'arrêté en conseil portant le numé-2495, en date du 25 septembre 1942, et de la remplacer par le règlement numéro 19, lequel se lit comme suit: \"Règlement N° 19 Les dispositions suivantes sont, par les présentes, adoptées comme constituant une maladie industrielle au sens de la Loi des Accidents du Travail, 1931, et sont, en conséquence, ajoutées aux prescriptions de la Cédule 3: Genre de Maladie Genre d'Occupation Tenosynovite - Regulation N° 19 The following is hereby declared to be an in-trial disease within the meaning of the Quebec Workmen's Compensation Act, 1931, and added to the Schedule 3 thereof : Description of Disease Description of Process Tenosynovitis- Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Secrétaire de la province, que l'abrogation dudit règlement numéro 15 de la Commission des accidents du travail de Québec, ainsi (pie son remplacement par le règlement numéro 19 précité de ladite Commission, soient approuvés, conformément aux dispositions de l'article 60 de la Loi des accidents du travail, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 160.Le Greffier suppléant du Conseil Exécutif.35333-0 C.LARICHELIÈRE.Avis divers Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Chantier Coopératif de l'U.C.C.Québec Sud\", en date du 14 juillet 1953, dont le siège social est situé à Saint-Georges, dans le comté de Beauce, et que ce document Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 916 Quebec August 6, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning certain administrative agreements of the Provincial Secretary.Concerning the repeal of By-law number 15 of the Quebec Workmen's Compensation Commission and its replacement by By-law number 19 of the said Comission.Whereas the Quebec Workmen's Compensation Commission, at the meeting of its Commissioners held on June 1st, 1953, when a resolution was adopted to the effect of repealing its By-law bearing number 15, adopted July 30, 1942 and approved by the Order in Council number 2495, under date of September 25, 1942, and to replace it by By-law number 19, which reads as follows: \"Règlement N° 19 Les dispositions suivantes sont, par les présentes, adoptées comme constituant une maladie undustrielle au sens de la loi des Accidents du Travail, 1931, et sont, en conséquence, ajoutées aux prescriptions de la Cédule 3: Genre de maladie Genre d'occupation Tenosynovite - Regulation No.19 The following is hereby declared to be an industrial disease within the meaning of the Quebec Workmen's Compensation Act, 1931, and added to the Schedule 3 thereof : Description of Disease Description of Process Tenosynovitis - It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Provincial Secretary, that the repeal of the said By-law number 15 of the Quebec Workmen's Compensation Commission, as well as its replacement by the By-law number 19 above cited of the said Commission, be approved in conformity to the provisions of section 66 of the Quebec Workmen's Compensation Act, Revised Statutes.of Quebec, 1941, chapter 160.C.LARICHELIÈRE, 35333 Acting Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Chan-tier Coopératif de l'U.C.C.Québec Sud\" under date of July 14, 1953, whereof the head office is at Saint-Georges, in the county1 of Beauce, QUEBEC kFF ICI AL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1053, Vol.85, No.33 2521 a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 23 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la Province, 35351-0 JEAN BRUCHÉSI.Chànbay Limited Règlement spécial \"fi\" 1.Que la compagnie soit et elle est, par les présentes, autorisée à disposer de ses biens, distribuer son actif au pro rata entre ses actionnaires et, subséquemment, procéder à sa dissolution par voie de procédures d'abandon de charte en vertu de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.2.Les directeurs et officiers sont, par leg présentes, autorisés et dirigés à faire, signer et exécuter toutes choses, actes et documents nécessaires ou convenables à la bonne exercice du précédent.Dûment décrété et sanctionné ce 6ième jour d'août 1953* .Le Secrétaire, 35349 T.J.RAPPELL avis de changement de nom Avis est par les présentes donné par le maire et le'secrétaire-trésorier de la municipalité de la partie ouest du canton de Romieu que le Lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé, en date du 8 juillet 1953, suivant un rapport du Comité de l'honorable Conseil exécutif, le changement du nom de la municipalité de la partie ouest du canton de Romieu en celui de \"la municipalité de Capucins\", comté de Matane.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur.à compter de la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Les Capucins 23 juillet 1953.Le Maire, ADÉLARD SOUCY.Le Secrétaire-trésorier, 35352-0 NAPOLÉON LEPAGE.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat des Producteurs-Fournisseurs de Lait de la Laiterie Ste-Margueritc\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le trente juillet 1953.Le siège social du syndicat professionnel précité est !>itué à La Pointç du Lac, dans le comté de St-Maurice.Le Sous-secrétaire de la Province, 35353-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.6326-50) Lake Brule Country Club Limited Règlement N° 27 - Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Lake Brule and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, July 23, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35351 Under Secratary of the Province.Chanbay Limited Special By-Law \"«\" 1.The Company be and is hereby authorized to dispose of its property, distribute its assets rateably amongst its shareholders and subsequently to proceed to dissolution by way of surrender of Charter proceedings under Section 26 of the Quebec Companies' Act.2.The Directors and Officers are hereby authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.Duly enacted and sanctioned this 6th day of August, 1953.T.J.RAPPELL, \u202235349-0 Secretary.Notice of change ok name Notice is hereby given by the Mayor and the Secretary-Treasurer of the municipality of the western part of the Township of Romieu that the Lieutenant-Governor in Council, on July eighth 1953, following a report of the Committee of the Honourable the Executive Council, approved the changing of the name of the municipality of the western part of the Township of Romieu into that of \"la municipalité de Capucins\", county of Matane.Pursuant to the provisions of Article 48 of the Municipal Code, this change of name will come into effect as from the date of the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Capucins, July 23, 1953.ADÉLARD SOUCY, Mayor.NAPOLÉON LEPAGE, 35352 Secretary-Treasurer.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat des Producteurs-Fournisseurs de Lait de la Laiterie Ste-Marguerite\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on July 30, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at La Pointe du Lac, in the county of St-Maurice.JEAN BRUCHÉSI, 35353 Under Secretary of the Province., (A.G.6326-50) Lake Brule Country Club Limited By-law No.27 Be it and it is hereby enacted as a By-law of Lake Brule Country Club Limited (hereinaf- 2522 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 15 août 1968, Tome 85, X° 33 Country Club Limited\" (ci-après nommé \"le Club\") ce qui suit: 1.Le nombre «les membres du bureau de direction du Club est diminué de quatorze (14) à huit (8) directeurs.2.Le règlement N° 21 du Club est révoqué et remplacé par le suivant: 21.Le Club sera administré par un bureau de direction composé de huit (8) directeurs.Je.le soussigné, secrétaire de \"Lake Brule Country Club Limited\", certifie, par les présentes, que le précédent est un extrait conforme des minutes «l'une assemblée dûment constituée du bureau de direction de \"Lake Brule Country Club Limited\" tenue le 21 avril 1953, et une vraie copie du règlement N° 27 adopté par les directeurs à ladite assemblée; et, de plus, je certifie qu'à une assemblée générale spéciale des actionnaires dûment convoquée et constituée le 28 juin 1953 pour considérer ledit règlement, il a été approuvé par plus des deux tiers (2/3) des votes donnés à ladite assemblée, à savoir, par le vote unanime de bous les actionnaires présents.Le Secrétaire, 35355 R.IL E.WALKER.Avis est par les présentes donné «pie l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu lo/ troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse d'Economie Al roi Credit Union\", en date du 9 juillet 1953, dont le siège social est situé au Cap-dc-la-Madeleine, dans le comté de Champlain.et (pie ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 16 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la Province.2534 l-o JEAN BRUCHESI.(P.G.6761-47) David & Frère, Limitée Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la Classe \"B\" de Daivd & Frère.Limitée, tenue au bureau de la compagnie, 1930, rue Champlain, Montréal, le vingt-huitième jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante-trois: \"Le règlement suivant portant le numéro 96, adopté par le bureau de direction de David & Frère, Limitée à une assemblée tenue le 11 juin 1953, et se lisant comme suit: \"U est proposé et unanimement résolu que le nombre des directeurs soit porté de 5 à 7\".est proposé et adopté à l'unanimité.\" Copie conforme.Le Secrétaire.35344-0 RODIER MERRILL.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire, de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de St-Camille\".en date du 17 juin 1953, dont le sigge social est situé à Saint-Camille, dans le comté de Bellechassc, et que ce document, a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 22 juin 1953.Le Sous-secrétaire de la Province.35345-0 JEAN BRUCHÉSI.ter called \"the Club\") as follows: 1.The number of the Board of Directors of the Club is decreased from fourteen (14) to eight (8) Directors.2.By-law No.21 of the Club is repealed and replaced by the following: \"21.The Club shall be managed by a Board of eight (S) Directors.\" I, the undersigned.Secretary of Lake Brule Country Club Lfmitcd, hereby certify the foregoing to be a true extract from the minutes of a duly constituted Meeting of the Board of Directors of Lake Brule Country Club Limited held on April 21st, 1953, and a true copy of Bylaw No.27 adopted by the Directors at the said Meeting: and I further certify that at a Special General Meeting of the Shareholders duly called and constituted on June 28th, 1953.for consideration of the said by-law, it was approved by more than two-thirds (2/3) of the votes cast at the said Meeting, namely, by the unanimous vote of all shareholders present.R.II.E.WALKER, 35355-0 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse d'Economie Alrol Credit Union\" under date the 9th day of July 1953 whereof the head office is at Cap-de-hi-Madeleine, in the cwinty of Champlain and that the said documents has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary .Given at the office ofUhe Provincial Secretary, this 16th day of Julv.1953.JEAN BRUCHÉSI, 35341 Under Secretary of the Province.(A.G.6761-47) David & Frères, Limitée Extract of the Minutes of,a special general meeting of the Class \"B\" shareholders, of David & Frère.Limitée, held at the office of the company, 1930 Champlain-Street, Montreal, on the twenty-eighth day of the month of July, one thousand nine hundred and fifty-three: \"The following by-law bearing number 96.adopted by the Board of Directors of David & Frère.Limitée, at a meeting held on June II, 1953.and reading as follows: \"It is proposed and unanimously resolved that the number of Directors be carried from 5 to 7\" is proposed and unanimously adopted.\" True Copie.RODIER MERRILL.35344 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of tire original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de St-Camille\" under date the 17th day of June.1953 whereof the head office is at Saint-Camillc, in the county of Bellechassc, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd dav of June.1953.JEAN BRUCHÉSI.35345 Undersecretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, August lôth, 1053, Vol.85, So.88 2523 (P.('.5327-52) United Customs Brokers Limited Copie certifiée d'une résolution passée ;ï la dernière assemble annuelle des actionnaires tenue le 9 juin 1953, à 5 p.m.\"II a été proposé et adopté à l'unanimité que le nombre des directeurs, tel que stipulé par la charte, soit augmenté de quatre à cinq dont quatre formeront quorum et qu'une copie de cette résolution soit envoyée ail Secrétaire de la province de Québec, tel (pie requis par la Loi des compagnies.Le Président, H.MARC-AURELE.Le Secrétaire-trésorier.35342 P.H.BERNARD.Avis est donné par les présentes donné (pie l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative de Charlesbourg\", en date du 21 mai 1953, dont le siège social est situé à Charlesbourg, dans le comté de Québec, et (pic ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 11 août 1953.Le Sous-Secrétaire de la Province.35373-0 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.5327-52) United Customs Brokers Limited Certified copy of a resolution passed at last annual shareholders meeting held on the 9th of June, 1953, at 5 p.m.\"It was moved and unanimously carried that the number of directors as specified by the Charter be increased from four to five of which four should constitute a quorum and a copy of this resolution be forwarded to the Secretary of the Province of Quebec, as required by the Companies Act.\" II.MARC-AURELE, President.P.H.BERNARD, 35342-0 Secretary-treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the dec-lam'ion of foundation of the cooperative syndicate \"(-©operative de Charlesbourg\" under date May 21, 1953 whereof the head office is at Charlesbourg in the county of Quebec and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.(iiven at the office of the Provincial Secretary.August 11, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35373 Under Secretary of the Province.(P.G.14244-53) Avis est donné (pie, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le onze août 1953, les règlements I à XIII inclusivement de la \"Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.\".et leurs amendements, lesquels règlements et amendements ont été adoptés le 12 juin 1953 et subséquemment, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Avis est également donné que les règlements 1 à 52 inclusivement de ladite corporation, a-doptés le 9 juin 1953, et approuvés par le Secrétaire de la province le 4 août 1953 (voir avis publié dans la Gazette officielle de Québec, tome 85, N° 32, du S août 1953, à la page 2472) ont aussi été approuvés conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec, et non pas en vertu de l'article 225, tel que mentionné dans ledit avis.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 12 août 1953.Le Sous-Secrétaire de la province, 35374-0 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.14244-53) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy-Attorney General, the honourable the Provincial Secretary has approved on August eleventh, 1953, by-laws I to XIII inclusively of the \"Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.\", and their amendments, which by-laws and amendments were adopted on June 12, 1953 and subsequently, and such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies Act.Notice is also given that by-laws 1 to 52 inclusively of the said corporation, adopted on June 9, 1953, and approved by the Provincial Secretary on August 4, 1953, (see notice published in the Quebec Official Gazette, Vol.85, No.32, of August 8, 1953, on page 2472) were also approved in conformity with the provisions of section 225a of the Quebec Companies Act.and not under section 225, as mentioned in the said notice.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of August, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35374 Under Secretary of the Provinse.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Les Presses Laurentienncs\".en date du 18 juin 1953.dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 7 juillet 1953.Le Sous-secrétaire de la Province.35372-Q JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Les Presses Laurentienncs\" under date the eighteenth day of June 1953, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this seventh day of July.1953.JEAN BRUCHÉSI.35372 Under Secretary of the Province. 2524 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1053, Tome 85, N° 33 Chartes \u2014 Abandon de AVIS LÉGAL Avis est donné que \"Service Contracting Company Limited\", une compagnie constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adresserera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 31ième jour de juillet 1953.Le Secrétaire, 35336 \u2022 I.OLSHAXSKY.Avis est donné conformément à la Loi des Compagnies de Québec que la compaguie \"Valley Flax Products Ltd.\", demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 27 juillet 1953.Le Secrétaire, Signé: GÉRARD CLOUTIER.35337-0 Harry S.Oakes Incorporated Avis est donné (pie la compagnie \"Harry S.Oakes Incorporated\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal,, ce fiième jour d'août 1953.Harry S.Oakes Incorporated Les Procureurs, 35343 BRODERICK & MCQUILLAN.(P.G.6110-47) Canada, Province de Québec, district de Québec.ABANDON DE LA CHARTE Centre Colomrien Limitée Avis est par les présentes donné (pie le Centre Colombien Limitée, une corporation dûment enregistrée en vertu de la loi des compagnies de Québec, et ayant son bureau chef à St-Rômuald d'Etchemin, comté de Lévis, district de Québec, s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la loi des compagnies de Québec.Daté à St-Romuald d'Etchemin.ce vingt-septième jour du mois de juillet mil neuf cent cinquante-trois.Le Secrétaire, 35346-0 GÉRARD ST-PIERRE.La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée Avis est par les présentes donné que \"La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son bureau principal dans la cité de Trois-Rivières, s'adressera au Procureur général de la province de Qué- Charters \u2014 Surrender of LEGAL NOTICE , Notice is hereby given that \"Service Contract-ting Company Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 31st day of July, 1953.I.OLSHANSKY, 35336-0 Secretary.Notice is hereby given that under the Quebec Companies' Act, \"Valley Flax Products Ltd.' will request the permission of relinquishing its charter.Montreal, July 27th, 1953.Signed: GERARD CLOUTIER, Secretary.35337-0 Harry S.Oakes Incorporated Notice is hereby given that \"Harry S.Oakes Incorporated\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this 6th day of August 1953.Harry S.Oakes Incorpotated BRODERICK & MCQUILLAN, 35343-0 \u2022 Attorneys.(A.G.6110-47) Canada, Province of Quebec, district of Quebec SURRENDER OF CHARTER Centre Colombien Limitée Notice is hereby given that the \"Centre Colombien Limitée\" a corporation duly registered under the Quebec Companies' Act, and having its head office at St.Romuald d'Etchemin, county of Levis, district of Quebec, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec to obtain permission to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at St.Romuald d'Etchemin, this twenty-seventh day of the month of July, one thousand nine-hundred and fifty-three.GERARD ST-PIERRE, 35346 Secretary.La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée Notice is hereby given that \"La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act having its head office in the City of Trois-Rivières, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1053, Vol.85, No.33 2525 bec pour demander la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Donné à Trois-Rivières, ce 7 août 1953.(Signé) PIERRE DANSEREAU, Directeur, (Signé) MAURICE DANSEREAU.35347-0 Directeur.Le Nouvelliste Limitée Avis est par les présentes donné que \"Le Nouvelliste Limitée\", une coiporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son bureau principal dans la cité de Trois-Rivières, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour demander la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Donné ù Trois-Rivières, ce 7ième jour d'août .1953.(Signé) GUILLAUME GEOFFRION, _ ' Directeur.(Signé) LUC PARENT.35348-u Directeur, Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.2248-53) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"J.& E.Hall Limited\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec.Les pouvoirs conférés à ladite compagnie pai sa charte seront limités à ceux accordés aux corporations de même nature en vertu des lois de la province de Québec, et la compagnie sera sujette aux mêmes formalités telles que prescrites par les lois déjà existantes de cette Province.Le bureau principal de la compagnie dans la province de Québec est établi à 112 ouest, rue St-Jacques, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal dans la Province, aux fins de recevoir les assignations dans toute poursuite ôu procédure intentée contre elle est M.J.Alex.Prud'homme, c.r., de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 12e jour d'août 1953.Le Sous-Secrétaire de la Province, 35333 JEAN BRUCHÉSI.Département des Affaires municipale CORRECTION Dans l'avis de l'émission des' lettres patentes érigeant la ville de Murdochville, publié dans la Gazette Officielle de Québec en date du 1er août, 1953, il y a lieu de lire, à la page 2426, dans le -texte français, à la troisième ligne du Nota Bene, les chiffres et mot \"18 juillet\" au lieu de \"28 juillet\".35333-A-X-o its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Trois-Rivières, this 7th August 1953.-(Signed) PIERRE DANSEREAU, Director, (Signed) MAURICE DANSEREAU, 35347-0 Director.Le Nouvelliste Limitée Notice is hereby given that \"Le Nouvelliste Limitée\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Trois-Rivières, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies, Act.Dated at Trois-Rivières, this 7th day of August, 1953.(Signed) GUILLAUME GEOFFRION, Director.(Signed) LUC PARENT, 35348-0 Director.Company Licensed to do Business (P.Sec.2248-53) Notice is hereby given that \"J.& E.Hall Limited\" has been licensed to carry on business in the Province of Quebec.The powers conferred on the said Company by its charter shall he limited to thofcc granted to corporations of like nature created in virtue of the laws of the Province of Quetac, and the Company shall be subject to the same formalities as are prescribed by the existing laws of this Province.The principal office of the Company in* the Province of Quebec is established at 112 St.James St.West, in the City and judicial district of Montreal.Its chief agent in the Province for the purpose of receiving service in any suit or proceeding against it is J.Alex.Prud'homme, Esquire, Q.C., of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of August, 1953.JEAN BRUCHÉSI, 35333-0 Undre-Secretary of the Province.Department of Municipal Affairs CORRECTION In the issuance of the letters patent erecting, tlie town of Murdochville, published in the Quebec Official Gazette bearing date the 1st day of August, 1953, on page 2426, in the third line of the Nota Bene, the numbers and word in the French text should read \"July 18\" instead of July 28\".35333-A-X 2520 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec.15 août 1953, Tome 85.N° 38 Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière! de la province de Québec Ordonnance N° 88-61A Extrait des.procès verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi 5 août 1953 tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal à 10,00 heures a.ni.Présents : MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-A.Chartraifd, P.-I).McArthur, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire.Après avoir considéré les conditions de l'Industrie laitière dans la région de Berthierville.La Commission' décrète ce qui suit: 1° L'ordonnance N° 23-51 A.publiée dans la Gazette officielle de Québec du 10 novembre 1951 est amendée et l'article 2° est remplacé par le suivant: 2° La région de Berthierville comprend la ville de Berthierville plus une partie de la municipalité de la paroisse de Bertlnèrville délimitée comme suit: au sud.par le fleuve St-Laurent; à l'est, par la Rivière Bayonnc; à l'ouest, par la Rivière La Chaloupe et au nord par la voie ferrée du Canadian Pacific via Montréa-Québec.La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Le secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer E.Milot.président, *¦ Joseph Hébert, commissaire, Adrien Angers, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire.P.-I).McArthur, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.35309-o Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province op Quebec Order No.23-51A Excerpts from the proceedings of the meeting of the Dairy Industry Commission of the.Porvince of Quebec.Meeting of Wednesday Autust 5th, 1953, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs, Orner E.Milot., President, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-A.Chartrand* P.-D.McArthur, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary.Considering the conditions of the dairy industry within the region of Berthierville.It is enacted as follows: 1.Order-No.23-51A published in the Quebec Official Gazette of November 10th, 1951 is amended and article 2 is replaced by the following: 2.The region of Berthierville includes the town of Berthierville and part of the municipality of the parish of Berthierville bounded as follows: on the south, by the St.Lawrence River; on the east, by the river known as Riviere Bayonnc; on the.west, by the river known as Rivière La Chaloupe and on the north by the Canadian Pacific Railway via Mont real-Quebec.The present Order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the Present Order in the Quebec Official Gazette.Signed: Omo'er E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers.Commissioner.J.A.Chartrand, Commissioner, P.I).McArthur, Commisioner, Certified: Alphonse Savoie, Secretary.35369-0 Département de l'Instruction publique X° 378-53.Québec, le 7 août 1953.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 30 juillet 1953, de changer le nom de la municipalité scolaire de Grenville N° 3, dans le comté d'Argenteuil, en celui de \"Pointe-aux-Chênes, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.v> Le Surintendant «le l'Instruction publique, 35334-0 0.J.DESAULNIERS.NT° 742-51.Québec, le 6 août 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Newport, dans le comté de Compton, les lots 1 à 8 inclusivement, du rang XI (11).du canton de Newport, pour les anne- Department of Education No.37S-53.Quebec, August 7, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council dated July 30.1953.to change the name of the school municipality of Grenville No.3, in the county of Argenteuil, into that of \"Pointe-aux-Chênes\" in the same county.Said Order in Council to take effect eight days \" after the publication of this notice in the Quebec Official Gazette., 0.J.DESAULNIERS, 3533-1 ' Superintendant of Education.No.742-51.Quebec, August 6, 1953.Application is made to detach from the school municipality of Newport, in the county of Compton.lots 1 to S inclusively, from range XI (11), of the township of Newport, to annex them to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1053, Vol.85, No.33 2527 xer à la municipalité scolaire de St-Isidore-d'Auckland, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35356-33-2-0 0.J.DESAULNIERS.N° 012-53.Quebec, le 6 août 1953.Demande est faite que le territoire ci-dessous décrit soit détaché de la municipalité scolaire de Newport, dans le comté de Compton, pour être annexé, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire cahtolique de Xotre-Dame-du-St-Rosairc, dans le même comté.Le territoire en question comprend les lots 1 du rang VI (6) ; 1 à 7 inclusivement des rangs VII et VIII (7 et S) ; 1 à 9 inclusivement et 10B, 10C.101), 111) et 11C du rang IX (9); 1 à S inclusivement et les lots 9A.9B, 10A, 10B, 11A et 11B du rang X (10), tous du canton de NcNvport.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35357-33-2-0 O.1.DESAULNIERS.N° 1468-52.Québec, le 6 août 1053.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-l'aul-dc-Châteauguay, dans le comté de Châteauguay.la partie du lot N° 310 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse «le Ste-Martinc, «hérite comme suit, savoir: Une terre sise et située à Ste-Martinc connue et désignée comme «Haut partie du lot numéro trois cent dix (pt.N° 310) «les plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Martinc, comté de Châteauguay; bornée en front au nord-ouest par le chemin de fer Canadien National, en profomlcur au sud-est par le chemin de la côte St-.Ioscph.d'un côté au nord-est, par la route provinciale N° 36 et «le l'autre côté au sud-ouest par partie «lu lot N° 311; contenant une superficie totale d'environ quatre-vingt-quatorze arpents; et les lots 310-70 et 310-71 du même ca-«lastre.pour les annexer à la municipalité scolaire de Stc-Martine.dans le même comté.Le Surintciulant de l'Instruction publique.353.5S-33-2-0 O.J.DESAULNIERS.X° 1086-52.Quebec, le 5 août 1953.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Sylvestre dans le comté de Lotbinière, les lots Nos 575 à 579 inclusivement, du cadastre officiel de St-Sylvestre, appartenant à monsieur Alzire Paradis, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Jacqués-de-Leeds, dans le comté «le Mégantic.Le Surintendant de l'Instruction publique.35359-33-2-0 O.J.DESAULNIERS, N° 20-52.Québec, le 4 août 1953.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en «late «lu 10 juillet 1953, «le «létacher de la municipalité scolaire de St-Georgcs-de-Beauce.dans le comté de Beauce.les lots 46 à 66 inclusivement, et la partie du lot N° 67 mesurant 28 arpents de hauteur par 3 arpents de largeur et appartenant à Monsieur Aurélien Lessard, du rang I (1) sud-ouest d'Au-bert-Gallion, et de les annexer à la municipalité scolaire de St-Georges-Ouest, paroisse, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1954.Le Surintendant de l'Instruction publique, 35334-0 O.J.DESAULNIERS.the school municipality of St-Isidore-d'Auckla«ln, in the same county.O.J.DESAULNIERS, 35356-33-2 Superintendent of Education.No.912-53.Quebec.August 6, 1953.Application is made that the territory herein-below described be detached from the school municipality of Newport, in the county of Compton, to be annexe*!, for the catholic ratepayers only, to the Catholic'School Municipality of Notre-Dame-du-St-Rosaire in the same county.The territory in question is comprised of lots 1 of Range VI (6); 1 to 7 inclusively of ranges VII and VIII (7 and 8); I to 9 inclusively ami 10B, 10C, 10D, 11B and 11C of range IX (9); 1 to 8 inclusively ami lots 9A, 9B, 10A, 10B 11A and 11B of range X (10).all of the township of Newport.O.J.DESAULNIERS.35357-33-2 Superintendent of E«lucation.No.1468-52.Quebec, August 6, 1953.Application is made to detach from the school municipality of St-Paul-dc-Châteauguay.in the county of Châteauguay, that part of lot No.310 on the official plan an«l in the book of reference of the'parish of Stc-Martine, described as follows, to wit: A farm situate at Ste-Martine known ami designated as being a part of lot number three hun«lre«l ami ten (pt.No.310) on the official plan and in the book of reference «>f the parish of Ste-Martinc, county of Châteauguay; bounded in front on the northwest by the Cana«lian National Railroad, in depth, on the southeast, by the St.Joseph Hill Road, on the northeast si«le, by Provincial Route N° 36 ami on the other side to the southwest, by part of lot No.311; containing a total superficial area of ninety-four arpents; and lots 310-70 ami 310-71 of the same cadastre, to annex them to the school municipality of Ste-Martinc, in the same countv.0.J.DESAULNIERS.3535S-33-2 Superintendent of Etlucation.No.1086-52.Quebec August 5, 1953.Application is ma«le to detach from the school municipality of St.Sylvestre, in the c«)iinty of Lotbinière.lots 575 to 579 inclusively, from the official cadastre of St.Sylvestre, belonging to Mr.Alzire Paradis, to annex them to the school municipality of St-Jacques-«le-Leeds, in the countv of Mcgantic.O.J.DESAULNIERS, 35359-33-2 Superintendent of E«lucation.No.20-52 Quebec, August 4, 1953.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased by Order in Council conformity with the Law.For other information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this third day of August, 1953.CLAUDE PERRAS, Office of: Trustee.Perras & Perras, Trustees, 4, Notre-Dame Street, East, Montreal, P.Q.35315-32-2 Ventes par licitation Sales by Licitation Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 321629.AVIS DE LICITATION Avis public est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Montréal, prononcé le 22 juin 1953, dans une cause mue entre Francis Dandavino, garagiste, mécanicien, domicilié et demeurant à Montréal, demandeur; et Marie-Louise Dandavino, épouse contrac-tuellement séparée de biens de Camille Tucci, presseur, avec lequel elle demeure à 2410 rue Chambly, Montréal, et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.321029.- NOTICE OF LICITATION Public notice is hereby given that, by virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Montreal, rendered on June the 22nd 1953 in a case wherein Francis Dandavino, garage keeper, mechanic, domiciled and residing in Montreal, is plaintiff, and Marie-Louise Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Camille Tucci, presser, with whom she is residing at 2410 Chambly Street, Montreal, and the latter to authorize his wife inasmuch as it is QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec^Augmt 16th, 1963, Vol 85, No.S3 2535 de la procédure; Ida Dandavino, épouse contrac-tuellement séparée de biens de Léo Bresnahan, mécanicien, avec lequel elle demeure à 1036 rue Argyle, en la cité de Verdun, district de Montréal et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure et Louis Dandavino, mécanicien, demeurant à 7335 rue Chateaubriand, en la cité de Montréal, défendeurs; et Michel Dandavino, électricien, demeurant à 6813 rue Saint-Laurent, en la cité de Montréal; Salvatore Dandavino, vendeur, demeurant à 10420 rue Waverley, en la cité de Montréal; Adeline Dandavino, épouse commune en biens de Raphaële Ferri, journalier, avec lequel elle demeure à 7343 rue Berri, en la cité de Montréal et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins de la validité de la procédure; Ânina Dandavino, épouse contractuellement séparée de biens de Marcel Guilbault, plombier, avec lequel elle demeure à 3476 rue Désiré, en la cité de Montréal et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure; Marguerite Dandavino, épouse contractuellement séparée de' biens de Jacques Tremblay électricien avec lequel elle demeure à 3478 rue Désiré, en la cité de Montréal, et ce dernier pour autoriser son épouse autant que nécessaire à la validité de la procédure, mis en cause, le partage définitif et la licitation des immeubles ci-après désignés, ont été ordonnés, suivant la loi, savoir: Immeuble numéro 1: \"Un emplacement sis rue Saint-André, à Montréal, désigné sous le numéro soixante-et-huit de la subdivision du lot numéro trois cent vingt-cinq (325-68) aux plan et livre de renvoi officiels du village de la Côte Saint-Louis, avec les constructions y érigées et portant les numéros civiques 4516 et 4518 de cette rue, et droit de passage dans les ruelles sises à côté et en arrière de cet emplacement, en commun, avec tous autres y ayant droit.\" Immeuble numéro 2: \"Un emplacement sis à l'angle Nord-est des rues de Castelneau et de Chateaubriand, à Montréal, disigné sous le numéro quatre-vingt-deux de la subdivision du lot numéro quatre cent quatre-Vingt-neuf (489-82) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-aux-Récollets, mesurant 25 pieds de largeur par 87 pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise, avec droit de passage dans les ruelles desservant cet emplacement, en commun, avec tous autres y ayant droit, avec les constructions y érigées et portant les numéros civiques 7331, 7333, 7335, 7337 et 7339 de ladite rue de Chateaubriand.\" Les immeubles ci-dessus désignés seront mis à l'enchère et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur le MERCREDI, NEUVIÈME jour de SEPTEMBRE 1953, à DIX heures et DEMIE de l'avant-midi, heure avancée, Cour tenante, dans la salle d'audience de Fancien palais de justice de Montréal, chambre 31, ou à toute chambre indiquée par cette Cour suivant les circonstances, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges ou liste des charges déposées au greffe du Protonotaire de la Cour supérieure, district de Montréal, et toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distran-e à ladite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de ladite cour au moins douze (12) jours avant le jour fixé comme sudit pour la vente et adjudication et toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six (6) jours après l'adjudi- necessary for the validity of the proceedings: Ida Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Léo Bresnahan, mechanic, with whom she is residing at 1036 Argyle, in the city of Verdun, district of Montreal and the latter to authorize his wife inasmuch as it is nccessarA* for the validity of the proceedings and Louis Dandavino, mechanic, residing at 7335 Chateaubriand Street, in the city of Montreal, defendants; and Michel Dandavino, electrician, residing at 6813 St.Laurent Street, in the city of Montreal; Salvatore Dandavino, salesman, residing at 10420 Waverley Street, in the city of Montreal; Adeline Dandavino, wife common as to property of Raphaële Ferri, labourer, with whom she is residing at 7343 Berri Street, in the city of Montreal and the latter to authorize his wife for the validity of the proceedings; Anina Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Marcel Guilbault, plumber, with whom she is residing at 3476 Desire Street, in the city of Montreal and the latter to authorize his wife inasmuch as it is necessary for the validity of the proceedings; Marguerite Dandavino, wife, by a marriage contract, separate as to property of Jacques Tremblay, electrician, with whom she is residing at 3478 Désiré Street, in the city of Montreal, and the latter to authorize his wife inasmuch as it is necessary for the validity of the proceedings, are mis en cause, the final partition and the licitation of the immoveable properties hereinafter described, have been ordered as follows, according to the law: Immoveable number 1: \"An emplacement situate on St.André Street, in the city of Montreal, designated as number sixty-eight of the subdivision of the lot number three hundred and twenty-five (325-68) on the Official Plan and Book of Reference of the village of Côte St.Louis, with the building thereon erected and bearing civic numbers 4516 and 4518 of said street and right of way in the lanes situate on the side and in rear of the said emplacement, in common, with all others having same right.\" Immovable number 2: \"An emplacement situate on the North-East corner of de Castelneau and de Chateaubriand Streets, in the city of Montreal, designated as number eighty-two of the said subdivision of the lot number hundred and eighty-nine (489-82) on the Official Plan and Book of Reference of the parish of Sault-aux-Recollets, measuring 25 feet in width by 87 feet in depth, English measure, and more or less, with right of way in the lanes connecting with the said emplacement, in common, with all others having same right; with the buildings thereon erected bearing civic numbers 7331, 7333, 7335, 7337 and 7339 of said de Chateaubriand Street.\" The above described immovables will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the WEDNESDAY, the NINTH of SEPTEMBER 1953, at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon, daylight saving time, Sitting the Court, in the Court Room of the Court House of Montreal, room 31, or any other room indicated by the said Court as circumstances permit, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the Superior Court for the District of Montreal, and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation, must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve (12) days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within the six (6) days following the 2536 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 85, N° 33 cation; à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent avis, elle seront forcloses du droit de le faire; Tout enchérisseur devra accompagner son offre ou enchère: a) quant à l'immeuble numéro 1, ci-haut désigné, l'emplacement rue Saint-André, d'une somme de mille cinq cents dollars ($1,500.00); b) quant à l'immeuble numéro 2, ci-haut désigné, l'emplacement angle nord-est des rues De Castelneau et de Chateaubriand, d'une somme de trois mille cinq cents dollars ($3,500.00).Montréal, le 30 juillet 1953.Le Procureur du demandeur, Me HECTOR LALONDE, c.r.266 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal.Harbour 8838.35312-32'-2-o adjudication; and, failing the parties to file the said oppositions within the delays hereby limited, \u2022they will be foreclosed from so doing.The offer or bid of every bidder must be accompanied: a) for the immovable number 1, hereabove designated as the emplacement on St.André Street, by an amount of one thousand and five hundred dollars ($1,500.00); b) for the immovable number 2, hereabove designated as the emplacement on the North-East corner of de Castelneau and da Chateaubriand Streets, by an amount of three thousand and five hundred dollars ($3,500.00).Montreal, the 30th day of July, 1953.Mr.HECTOR LALONDE, Q.C.Attorney for plaintiff.266 St.James Street West, Montreal, Harbour 8838 35312-32-2-o Canada, Province de Québec, district «le Canada, Province of Quebec, district of Mont-Montréal.Cour Supérieure, N° 330,987.real, Superior Court.No.330987.AVIS DE LICITATION NOTICE OF LICITATION Avis est par les présentes donné qu'en vertu d'un jugement rendu par l'Honorable Juge Antonio Garncau siégeant en Cour Supérieure, à Montréal le 21 juillet 1953, dans une cause où Paul A.Pinard, rentier de la cité d'Outremont.district de Montréal, est demandeur, et Dame Angelina Label le, de la cité d'Outremont, district de Montréal, veuve non-remariée de Joseph A.Lanctot, en son vivant des cité et district de Montréal, et al, sont défendeurs, et Télés-phore Brassard, notaire, des cité et district de Montréal, en sa qualité de Régistrateur de la division «l'enregistrement de Montréal est mis-en-cause, la licitation a été ordonnée de l'immeuble suivant, savoir: \"Deux emplacements situés dans le quartier Saint-Louis, de la Cité de Montréal, portant les numéros huit et neuf de la suvdivision officielle du lot numéro neuf cent sept (907-8 et 0), des plan et livre de renvoi officiels du dit quartier Saint-Louis, contenant chacun vingt-cinq pieds de largeur en front; et le «lit lot numéro neuf, vingt-sept pieds et deux pouces en arrière; et le dit lot numéro huit, vingt-cinq pieds par une profondeur commune de cent pieds; formant une superficie totale de cinq mille cent huit pieds, bornés en front, au sud-est, par l'Avenue Laval; en arrière, par une ruelle de quinze pieds de largeur; du côté nord-ouest, par le lot numéro sept de la dite subdivision; et du côté sud-est, par la rue Prince-Arthur; avec deux maisons en pierre et en brique portant les numéros 3600 à 3610 inclusivement de l'Avenue Laval, et les numéros 217 et 219 «le la dite rue Prince-Arthur Est; et en outre, avec droit de passage en commun avec d'autres dans la ruelle connue sous le numéro DIX de la dite subdivision, à la charge d'entretenir la partie en arrière du dit terrain nette et propre en toutes saisons.Avec toutes circonstances et dépendances, servitudes actives et passives, y attachées.\" L'immeuble susdésigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur le 17e jour de SEFrEMBRE 1953, à DIX heures et DEMIE de l'avant-midi (heure avancée), à la salle d'audience N° 31 du Palais «le Justice, à Montréal, où les intéressés pourront être référés, le tout sujet aux charges, clauses et conditions mentionnées dans le cahier «les charges qui sera déposé au greffe du Protonotaire -«le la «lite cour; et toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire, à la dite Notice is hereby given that in virtue of a judgment rendered by the Honourable Mr.Justice Antonio Garneau, sitting in the Superior Court, at Montreal, on the 21st.of July, 1953.in a Case where Paul A.Pinard, retired of the city of Outremont, district of Montreal, is plaintiff, and Dame Angelina Labelle, of the city of Outremont, district of Montreal, unremarried widow of Joseph A.Lanctot, in his lifetime of the city and district of Montreal, et al, are defendants; and Telesphore Brassanl, notary, of the city and district of Montreal, in his quality of Registrar in the Registry Office of Montreal, is mis-en-cause, a licitation has been ordered of the following immoveable, to wit; \"Two emplacements situate in St.Louis Ward, of the city of Montreal, bearing numbers eight and nine of the official subdivision of lot number nine hundred and seven (907-8 and 9) of the official plan and book of reference of said St.Louis Ward, containing each twenty-five feet in width in front; and said lot number nine, twenty-seven feet and two inches in rear; and said lot number eight, twenty-five feet by a depth of one hundred feet; forminga total superficies of five thousand one hundred and eight feet, bounded in front to the South-East by Laval Avenue; in rear, by a lane measuring fifteen feet in width; on the North-East side by lot number seven of said subdivision; and on the South-East side by Prince-Arthur Street; with two houses in stone and in brick, bearing civic numbers 3600 to 3610 inclusive, of Laval Avenue, and numbers 217 and 219 of said Prince-Arthur Street East; together with a right of passage in common with others in the lane bearing number TEN of said subdivision, with the obligation to keep in good order the rear part of said lot in all seasons.With all members and appurtenances, active and passive servitudes attached thereto.\" The above described immoveable will be put up for auction and will be adjuged to the highest and last bidder on the 17th.day of SEPTEMBER 1953, at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon (daylight saving time) in room No.31 of the Court House, in Montreal, or in such other room that the interested parties may be refered to, the whole subject to the charges, clauses and conditions indicated in the book or list of charges which shall be deposited at the Protonotary's Office of the said Court; and all oppositions to QUEBEC OFFICML GAZETTE, Quebec, August 15th, 1958, Vol.85, No.83 2537 licitation devra être déposée au même greffe annul, to secure charges or to withdraw to the du Protonotaire au moins douze jours avant le said licitation shall be deposited at the said jour fixé comme susdit pour la vente et adjudi- Prothonotary \\s Office, at least twelve days cation, et toute opposition à fin de conserver before the day fixed as above mentioned for the devra être déposée dans les six jours après Pad- said sale and adjudication, and all opposition judication; à défaut par les intéressés de déposer to payment shall be deposited within six days les dites oppositions dans les délais presents after the adjudication; and failing the parties par le présent avis, ils seront forclos du droit to file such oppositions within the delays herein de le faire.stated they will be forclosed from so doing.Un dépôt de trois mille cinq cent dollars A deposit, of Three Thousand Five Hundred ($3,500.00) devra être fait entre les mains de Dollars ($3,500.00) in the hands of the officer l'officier chargé de la vente, par tout offrant et in charge of the sale must be made by each enchérisseur lors de son enchère.bidder.Montréal, ce 15 août 1953.Les Avocats du demandeur, Montreal.15 August, 1953.35366-33-2-0 DUSSAULT, DUSSAULT & DUSSAULT DUSSAULT & VADBONCŒUR, VADBONCOEUR.35366-33-2-o Attorneys for Plaintiff.VENTES PAR SHÉRIF SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Province de Québec, District d'Arthabaska Cour Supérieure, ( T ÉONIDAS DION & FILS N° 8202 < -L* LTÉE, corporation lé-v gaiement constituée ayant son siège social en la Cité de Thetford Mines, demanderesse, vs EDOUARD O.ANGERS, journalier du village de Coleraine, défendeur, J.W.Turcotte & Aurèle Binette, régistrateur, sous le nom de Turcotte & Binette.Mis-en-Cause.Comme appartenant et étant en la possession du défendeur, l'immeuble ci-après mentionné et décrit, savoir: \"Un emplacement de cinquante pieds de largeur en front par cent vingt pieds de profondeur, connu et désigné comme étant la partie sud du lot numéro deux cent deux (Pties sud N° 202) du village de Coleraine, aux plan et livre de renvoi officiels pour le canton de Coleraine, et borné comme suit: en front, à l'ouest, par la première Avenue; au nord par le lot numéro deux cent deux; et au sud par le lot deux cent trois; avec bâtisse dessus construit; le terrain ci-dessus appartient à Edouard O.Angers susdit, bien que encore enregistré au nom de Louis Frechette.\" Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Joseph de Coleraine, au village de Coleraine, le TROIS SEPTEMBRE 1953, à DEUX heures de l'après-midi (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FÉLIX HOULE.Arthaiaska, 24 juillet 1953.35288-31-2-0 BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Dans la Cour Supérieure, District de Beauce St-Joseph de Beauce, ( \"DRNEST VAILLAN-à savoir: [ *-* COURT, marchand N°23,003.(de St-Prosper, Dorchester contre ADRIEN HÉBERT de St-Louis, Dorchester, à savoir: le lot N° 57, rang de l'Eglise St-Louis de Ravignan, PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Province de Québec, District d'Arthabaska Superior Court, ( T ÉONIDAS DION & FILS No.8202 < a corporation legally in-t corporated, having its head office in the citv of Thetford Mines, plaintiff, vs EDOUARD O.ANGERS, labourer of the village of Coleraine, defendant, and J.W.Turcotte & Aurèle Binette, registrar, under the name of Turcotte & Binette, Mis-en-cause.As belonging to and being in the possession of the Defendant, the immoveable hereinafter mentioned and described, to wit: \"An emplacement, of fifty feet in width in front, by one hundred and twenty feet in depth, known and designated as being the southern part of lot number two hundred and two (Part south No.202) of the village of Coleraine, on the official plan and book of reference of the township of Coleraine, and bounded as follows: In front, to the west, by the first Avenue; to the north by lot number two hundred and two; and to the south by lot two hundred and three with buildings erected thereon; the above-mentioned land is owned by Edouard O.Angers, the aforesaid, though still registered in the name of Louis Frechette.\" To be sold at the parochial church door of St.Joseph de Coleraine, in the village of Coleraine, the THIRD day of SEPTEMBER 1953, at TWO o'clock in the afternoon (Daylight saving time).FÉLIX HOULE, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, July 24, 1953.35288-31-2 BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris In the Superior Court District of Beauce St.Joseph of Beauce, t T7/RNEST VAILAN- To wit: < *-» COURT, merchant of No.23,003.I St.Prosper, Dorchester, against ADRIEN HÉBERT of St.Louis, Dorchester, to wit: lot No.57, range of the Church St.Louis de Ravignan, 2538 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 86,'N9 33 canton Langevin avec les impenses et améliorations circonstances et dépendances, et les bâtisses qui s'y trouvent.Pour être vendu à.la porte de l'église paroissiale, en la paroisse de St-Louis «le Itavignan le VINGT et UNIÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, 12 août 1953.[Première Insertion: 15 août 1953] [Seconde Insertion: 29 août 1953] 35375-33-2-0 township Langevin, with the upkeep and improvements, circumstances and dependencies, and the buildings thereon erected.To be sold at the parochial chuch door in the parish of St.Louis dc Ravignan the TWENTY-FIRST day of SEPTEMBER next at TEN o'clock in the forenoon.J.S.POULIOT, Sheriff's Office, Sheriff.St-Joseph of Beauce, August 12, 1953.[First insertion: August 15, 1953] [Second insertion: August 29, 1953] 35375-33-2 BEAUHARNOIS Province de Québec District de Beauharnois Cour de Magistrat, ( T A MAISON BLAIN*LI-N° 4706.< -L* MITÉE, corporation lé v gaiement constituée, ayant sa principale place d'affaires dans la municipalité de St-Rémi de Napierville, district d'Roer-ville, demanderesse vs STANLEY McRAE, de 11 municipalité de Ste-Clotide, district de Beauharnois, défendeur.AVIS Avis public est par le présent donné que les terres et héritages sous mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs tel que mentionné plus bas; Une terre sise ej; située dans la paroisse de Ste-Clot.ide, comté de Châtrauguay, connue et désignée au plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jean-Chrysostome, sous les numéros Cent cinquante sept (157) cent cinquante huit (158) cent cinquante neuf (159) contenant en superficie respectivement cent arpents, vingt cinq arpents et vingt cinq arpents et soixante-deux perches et demie, avec les bâtisses dessus érigées, pour être vendu en bloc, avec toutes les servitudes apparentes ou occultes, actives ou passives y attachées.Pour être vendu à la porte de l'Eglise paroissiale de la paroisse de Ste-Clotide, Cté de Châteauguay, district de Beauharnois, VENDREDI le DIX-HUIT SEPTEMBRE 1953, à DIX heures de Tavant-inidi, (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, HORACE VIAU.Valleyfield, 7 août, 1953.35360-33-2-o BEDFORD Canada, Province de Québec district de Montréal Cour Supérieure, ( \\ METROPOLITAN LOAN N° 332099.< J-Vl CORPORATION, un ( corps politique et incorporé, dûment constituée en corporation suivant la Loi, ayant son siège social et principale place d'affaires en les cité et district de Montréal, demanderesse, vs PAUL H.CHARPENTIER, des cité et district de Montréal, défendeur.Comme appartenant au défendeur: \u2022 Ce certain lot de terrain connu et désigné comme étant le lot numéro huit cent quatre-vingt-deux (N° 882) des plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Sutton, contenant cinquante-cinq (55) acres de terrain en superficie, plus ou moins; avec les bâtisses dessus érigées.Pour être vendu à la porte de l'église catholique de St-André de Sutton, comté de Brome BEAUHARNOIS Province of Quebec District of Beauharnois .Magistrate's Court, ( T A MAISON BLAIN No.4706.< -L* LIMITÉE, corporation ( duly incorporated, having its head office in the municipality of St.Rémi of Napierville, district of Rierville, plaintiff, vs STANLEY McRAE, of the municipality of Ste-Clotide, district of Beauharnois, defendant.NOTICE Public notice is hereby given that the undermentioned lands and tenements have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.A farm situate in the parish of Ste.Clotide, county of Châteauguay, known and designated on the official plan and in the parish of St.Jean Chrysostome, under numbers one hundred and fifty-seven (157) one hundred and fifty-eight (158) one hundred and fifty-nine (159) containing in superficial area respectively one hundred arpents, twenty-five arpents and twenty-five arpents and sixty-two rods and one half,'with the buildings, thereon erected, to be sold in block, with all the active and passive, apparent or unapparent servitudes attached thereto.To be sold at the parochial church door of the parish of Ste-Clotide, Co.of Châteauguay, district of Beauharnois, FRIDAY, the EIGHTEENTH day of SEPTEMBER, 1953, at TEN o'clock in the forenoon, (Daylight Saving Time).HORACE VIAU, Sheriff's Office, Sheriff.Valleyfield, August 7, 1953.35360-33-2 BEDFORD Canada, Province of Quebec, district of Montreal Superior Court, ( \\ METROPOLITAN LOAN No.332099.< -*V1 CORPORATION, a I body politic and corporate, duly incorporated according to law, having its head office and principal place of business in the City and district of Montreal, plaintiff, vs PAUL-H.CHARPENTIER, of the City and «listrict of Montreal, defendant.As belonging to the defendant: That certain lot of land known and designated as lot Number eight hundred and eighty-two (No.882) of the Official pain and book of reference of the Cadastre of the Canton of Sutton, containing fifty-five (55) acres of land in superficies, more or less; with the buildings thereon erected.To be sold at the Catholic church door of St-André of Sutton, County, of Brome, WED- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1963, Vol.35, No.33 2539 MERCREDI le SEIZIÈME jour «le SEPTEM-, BRE 1953, à DIX heures «lu matin.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, A.ST-MARTIN.Palais de Justice, Sweetshurg, Que,, 7 août 1953.35361-33-2 GASPÉ Fieri Facias.de Terris Cour Supérieure, ( \"PvAVID DUGUAY de Ste- Perce, P.Q.) Adelaide de Pabos, coni-X° 3503.) té de Gaspé; demandeur vs ' FRANK LANGELP3R de St-François de Pabos, comté de (iaspé, défentleur.Un certain lopin de terre connu et désigné comme étant le lot 23-B (vingt-trois) rang 2 (deux) de la Seigneurie de Pabos et mesurant % d'arpent (trois-quarts) et onze pieds de largeur par 14 arpents (quatorze) de profondeur et borné comme suit: au Sud par le trait carré du premier rang, au Nord par le lot 22, à l'Ouest par Ambroise Loiselle, et à l'Est par Daniel Langelier, avec dessus maison construite, circonstances et dépendances.Un certain lopin de terre connu et désigné comme étant le lot 22-G (vingt-deux) rang 3 (trois) de la Seigneurie de Pabos,.mesurant 1 arpents de largeur (un) par onze arpents (11) arpents de profondeur et borné comme suit: à l'Est par Joseph Giroux, à l'Ouest par John Thomas Dupuis, au Sud par la Rivière Petit Pabos, au Nord par le trait carré du 3 ième rang.La demi-est du lot 21 (vingt-un) premier rang de Petit Pabos, borné comme suit: à l'Est par George Henri LeBIanc à l'Ouest par Thomas Garrett, au Sud par la Rivière Petit Pabos et au Nord par le trait Carré du 3 ième rang.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-François de Pabos le SEIZIÈME jour de SEPTEMBRE 1953 à DIX heures de Pavant-midi.Bureau du shérif, Le Shérif, M.J.FURLONG.Percé, P.Q., le 4 août 1953.35362-33-2-o JOLIETTE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, Province de Québec District de Juliette Cour Supérieure, ( TEAN-PAUL BONIN, mar-N° 10887.< J chand, du village de St-(.Félix de Valois, district de Joliette, et y faisant affaires seul comme tel sous la raison sociale de W.BONIN, ENRG., demandeur vs YOLAND BEAUSOLEIL, du village de St-Gabriel de Brandon, défendeur.Comme appartenant et étant en la possession du défendeur, l'immeuble ci-après mentionné et décrit, savoir: Un emplacement situé au village de Saint-Gabriel de Brandon, comté de Berthier, ayant front sur le côté nord-est de la rue Bellevue, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro deux cent trente \u2014 seize -(Ptie 230-16) du cadastre du village de Saint-Gabriel de Brandon, comté de Berthier, mesurant cinquante pieds en largeur sur cent pieds de profondeur, borné en front par ladite nie, en profondeur, par le terrain d'Alphonse Beauvilliers, au côté sud-est par Mlle Y.Chapron, et au nord-ouest par le terrain d'Alphonse Beauvilliers, avec bâtisses dessus construites.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon, au village NES DAY, the SIXTEENTH dav of SEFPEM-BER, 1953, at 'PEN of the clock in the forenoon.A.ST-MARTIN.Sheriff's Office, Sheriff.Court House.Sweetshurg, Que., August 7, 1953.35361-33-2-o GASPÉ Fieri Facias de Tern's Superior Court, (T^AVID DUGUAY.of Ste- Perce, P.Q.) Ly Adelaide of Pahos, conn-No.3503 ) t> of (Jaspé; plaintiff vs \\ FRANK LANGELIER of St.Francois of Pabos.county of Gaspé, defendant A certain portion of land known and desig-ated as being lot 23-B (twenty-three) range 2 (two) of the Seigniory of Pahos and measuring % arpent (three-quarters) and eleven feet in width by 14 arpents (fourteen) in depth and bounded as follows: on the south by the \"trait carré\" of the first range, on the North by lot 22, on the west by Ambroise Loiselle, and on the East by Daniel Langelier, with house erected thereon, circumstances and dependencies.A certain portion of land known and designated \u2022 as being lot 22-G (twenty-two) range 3 (three) of the Seigniory of Pabos, measuring 1 arpent in width (one) by eleven arpents (11) arpents in depth and bounded as follows: on the east by Joseph Giroux, on the west, by John Thomas Dupuis, on the South, by the Petit Pabos River, on the north by the trait carré of the 3rd range.The half-east of lot 21 (twenty-one) first range of Petit Pabos, bounded as follows: on the east by George Henri Leblanc on the west by Thomas Garrett, on the south by Petit Pabos River, and on the north, by the \"trait carré\" of the 3rd range.To be sold at the parochial church door of St.François of Pabos the SIXTEENTH day of SEPTEMBER 1953 at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's office, M.J.FURLONG, Sheriff.Percé, P.Q., August 4, 1953.' 35362-33-2 JOLIETTE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, Province of Quebec District of Joliette Superior Court, / TEAN-PAUL BONIN, mcr- No.10887.< J chant, of the village of I St.Félix de Valois, district of Joliette, and carrying on business alone as such under the style of W.BONIN, ENR., plaintiff vs YOLAND BEAUSOLEIL, of the village of St.Gabriel de Brandon, defendant.As belonging and being in possession of the defendant, the immoveable hereinafter mentioned and described, to wit: An emplacement situate in the village of St.Gabriel de Brandon, county of Berthier, with frontage on the northeastern side of Bellevue Street, know ans designated as being part of lot number two hundred and thirty \u2014 sixteen (Pt.230-16) of the cadastre of the village of St.Gabriel de Brandon, county of Berthier, measuring fifty feet in width by one hundred feet in depth, bounded in front by the said street, in depth, by the land of Alphonse Beauvilliers, on the south-eastern side by Miss Y.Chapron, and on the northwest by the land of Alphonse Beauvilliers, with buildings thereon erected.To be sold at the door of the parochial church of St.Gabriel de Brandon, in the village of St- 2540 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1953, Tome 85, N° 38 de Saint-Gabriel de Brandon, district de Joliette, le VINGT-CINQUIÈME jour du mois D'AOÛT 1953, à ONZE heures de matin.Le Shérif.Bureau du Shérif, ROUAN!) PERRAULT.Joliette, le 20 juillet 1953.35247-30-2-o KAMOURASKA Fieri Facias de Battit et de Terris Canada, Province de Québec-District de Kamouraska Cour Supérieure, / T B.LA VOIE, avocat de la N° 18586 < J \u2022 cité de Rivière-du-Loup, (.demandeur, vs J.C.IL BÉLANGER, de Cacouna, défendeur.\"Un emplacement mesurant cent pieds de front sur quatre-vingt-dix pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise, borné en front au nord-est à la route de la grève, au sud-est au terrain de dame J.Desrosiers, au sud-ouest à la terre de Georges Desjardins, et au nord-ouest au terrain de Louis Thibault; lequel cm- {«lacement est connu et désigné comme étant e lot numéro quatre-vingt-quatre et partie du lot numéro quatre-vingt-cinq (84 et pt-85) des plan et livre de renvoi officiels du Village Saint-Georges de Cacouna, au cadastre de la division d'enregistrement du Comté de Témiscouata; avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances quelconques.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Georges de Cacouna, LUNDI, le VINGT-QUATRIÈME jour de AOÛT 1953, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, 29 juillet 1953.35249-30-2-c [Première insertion, samedi le 25 juillet 1053] Fieri Facias de Terris Canada, Province de Québec, * District de Kamouraska Cour Supérieure, ( Traîne RÉGINA BIDÉGA-N° 18276.< *f RÉ, épouse séparée de \\ biens de Henri Bidegaré, commerçant, domicilée et résidant à Rivière-du-Loup, et HENRI BIDEGARÉ, mis en cause pour autoriser son épouse aux fins des présentes, mis en cause, demanderesse; vs THOMAS PELLETIER, de St-Honoré, défendeur.La demie (3^) du lot numéro P.quarante-deux A (P-42-A), rang C du Canton Armand, St-Honoré, et le numéro cinq (5), rang D, canton Armand, St-Honoré.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de St-Honoré, LUNDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'AOÛT 1953, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau u Shérif, P.-E.MARTIN.Rivière-du-Loup, 20 juillet 1953.35248-30-2-o [Première insertion, samedi le 25 juillet 1953] Fieri Facias de Terris Canada, Province de Québec, District de Kamouraska Cour Supérieure.( COCIÉTÉ COOPÉRATIVE N° 18196.\\ O AGRICOLE DE BEUR-( RERIE, de St-Clément, corps politique et incorporé sous l'autorité du chapitre 120 des statuts refondus de la Province de Québec 1941 et ayant son siège social à St-Clément, comté de Rivière-du-Loup, demanderesse; vs?J.-HERVÊ GAMACHE, du même endroit, défendeur.Gabriel de Brandon, district of Joliette, the TWENTY-FIFTH day of the month of AUGUST, 1953, at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERRAULT, Sheriff's Office.Sheriff.Jotfette, July 20, 1953.35247-30-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, Province of Quebec District of Kamouraska, Superior Court, ( T B.LA VOIE, advocate of No.18586 the constitution and general by-laws of the Joint Committee of the Construction Industry, Quebec, approved by Order in Council No.886 of July 30, 1953 (Part \"A\").\"17.Keeping of a register: Pursuant to subsection \"g\" of section 20 of the Act, the Parity Committee renders obligatory for every professional employer governed by the decree No.760 of June 30.1953.the keeping of a register giving the name in full and address of all employees in his employ, their qualification or classification, the exact tine at which the work was begun, interrupted, resumed and ceased each day, the nature of such work and the wages paid, with mention of the mode and period of payment, including all other information needed for the proper enforcement of the decree.18.Certificate of competency: Pursuant to section 25 of the Act.the Parity Committee renders the certificate of competency obligatory for all employees subject to the decree No.760 of June 30.1953 and plying the following trades: bricklaying, masonry, plastering, carpentry, painting, tinsmithing-roofing, marble laying, tile laying, terrazzo laying, terrazzo polishing, joint pointing, cement finishing, drilling, wood lathing, metal lathing, shovel operating, tractor operating, crane operating, ornamental iron and bronze erecting and blacksmithing, pipe welding, asbestos insulating, reinforcing steel erecting, pipe laying (plumbing, steam fitting, refrigerating and oil burner installation not subject to the Pipe Mechanics Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 173 an I amendments).Such certificate shall be obligatory in the entire territory of zone I and in the city of Rivière-du-Loup and the town of Montmagny which are comprised in the territorial jurisdiction of the decree No.760 of June 30.1953.19.Board of Examiners: The Parity Committee forms,the Boards of Examiners required to determine the competency of workers and authorized the issue of certificates of competency.The Committe may charge a fee not exeed-ing two dollars ($2.00) for the examination of \\ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1953, Vol.35, No.33 2545 l'examen d'un ouvrier qualifié et un ($1.03) dollar pour l'examen d'un apprenti.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1053.35370-o Avis d'aim'rohatiox uk Rkclemexts L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est,établi en exécution du décret numéro 82.S du 10 juillet 1953, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 918 du 6 août 1953 (section \"B\").Le Sous-ministre du Travail, GÉRAI) TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.35370-o a skilled worker and one not exceeding one dollar ($1.00) for the examination of an apprentice.GÉRARD TRE.V BLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour.Quebec, August 15, 1953.35370-O Notice of approval of by-laws The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice, pursunat to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941.chapter 103 and amendments), that the constitution and general by-laws of the Joint Committee of the Automobile Industry of the Eastern Townships, formed under the decree No.828 of July 10.1953, have been approved by Oi.xler in Council No.913 of August (5, 1953 (part \"B\").G ERARD TREM BLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec August 15, 1953.35370-o AVIS D'APPROBATION DE HI (JUCMEXTS L'honorable Antonio Barrette.M inistre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 103 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuille, établi en exécution du décret numéro 827 du 10 juillet 1953, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 913 du 6 août 1953 (section \"G\").Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.33370-o Notice of Approval of By-laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 103 and amendments), that the constitution and general by-laws of the Joint Committee of.the Sheet Metal Fal'ri-cating Industry, formed under decree No.827 of July 10, 1953, have been approved by Order in Council No.913 of August 0, 1953 (part \"(J\").GÉRARD TREM BLAY, Deguty Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 15.1953.35370-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuille, dont le siège social est situé à Montréal, établi en exécution du décret numéro 827 du 10 juillet 1953, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 913 «lu 6 août 1953, section \"H\" le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec.1941.chapitre 163).à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 25 juillet 1953 au 25 juillet 1954; cette cotisation s'exerce comme ûi-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 1/8 de 1% de la liste des salaires fixes, commissions, bonis, al le cations, qu'ils versent aux employés régis par ledit décret N° 827.b) Tous les artisans assujettis au décret N° 827 doivent également payer au comité paritaire 1/8 de 1% du salaire gagné par eux dans l'éxecution du travail régi par ledit decret- c) Les salariés régis par le décret numéro 827 doivent verser au comité paritaire une somme NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry whose head office is in Montreal, established under decree number 827 of July 16, 1953, has been authorized by a by-law approved by Order-in-Council number 913 of August 6, 1953, part \"H\" in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act, (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163), to levy assessments upon the professionnal employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Levy The period of levy shall extend from July 25th.1953, to July 25th, 1954.and apply as hereinafter mentioned: a) The professional employers governed by the decree shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1 /8 of 1 % of the fixed wages, commissions, bonuses, allocations paid to their employees subject to decree number 827.b) All the artisans subject to decree number 827, must also pay to the Parity Committee 1/8 of 1% of the wages earned by them for work governed by said decree.c) The employees governed by the said decree number 827 shall pay to the Parity Committee 2546 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1963, Tome 86, N° S3 équivalente à 1/8 de 1% de leurs salaires fixes, commissions, bonis et allocations.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le comté paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules indiquant les heures de travail, l'argent perçu au cours de la semaine, et les sommes dues au comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au comité paritaire à tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie à même la rémunération de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au comité paritaire.Le rapport de chaque employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au comité paritaire.Ce comité a le pouvoir d'exiger l'as-sermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport accompagné des prélèvements doit être adressé au comité paritaire le ou avant le mercredi suivant la date d'expiration de la période pour laquelle ledit rapport est exigible.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au -Ministre du Travail aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé un état des recettes et des déboursés prévus par le comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuille pour la période comprise entre le 25 juillet 1953 et le 25 juillet 1954.Comité Conjoint de l'Industrie de la Fabrication du métal en* feuille 055, Immeuble New Birks Montréal État des recettes et des déboursés requis par le Comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuille pour la mise à exécution du décret numéro 827.Période du 25 juillet 1953 au 25 juillet 1954.Recette: Cotisation des employeurs professionnels.$8,500.00 Cotisations des salariés.8,500.00 $17,000.00 Déboursés: Comité paritaire des matériaux de construction (services à $675.00 par toois).8,100.00 Salaires.2,200.00 Frais légaux., 900.00 Impressions et papeterie.500.00 Frais de déplacement.600.00 Divers et dépenses imprévues.500.00 Jetons de présence et dépenses.2,900.00 Dépenses du bureau et divers.500.00 Surplus.800.00 $17,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.35370-o a sum equivalent to 1/8 of 1% of their fixed wages, commissions, bonuses and allocations.2.Mode of collection In order to facilite the collection of these levies, the Parity Committee shall furnish the professional employers with printed forms indicating the hours of labour, the money collected during the week and the sums due to the Parity Committee.The professional employer shall have these reports filled and returned to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect at each pay period from the wages of everyone of his employees the sums owed to the Parity Committee.The report of every professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.This Committee has the right to exact sworn reports every time it shall deam it advisable.The report together with levies shall be sent to the Parity Committee on or before the Wednesday following the date of the period for which the said report is requirable.3.Financial Report According to the provisions of the collective Agreement Act the Parity Committee shall present a report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31, June 30, September 30, and December 31st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry for the period from July 25th, 1953, to July 25th, 1954.Joint Committee of the sheet Metal Fabrication Industry Room 655, New Birks Building, Montreal Estimate of receipts and disbursements required by the Joint Committee of the Sheet Metal Fabricating Industry for the administration of Decree number 827 for the period from July 25th, 1953 to July 25th, 1954.Receipts: Levies from professional employers $ 8,500.0 Levies from employees.8,500.00 $17,000.00 Disbursements: Buildings Materials Joint Committee (Services at $675.00 per month).8,100.00 Salaries.m 2,200.00 Printing and Stationary.500.00 Legal Expenses.900.00 Travelling Expenses.600.00 Attendance fees and expenses.2,900.00 Unforeen expenses and Sundries.500.00 Office expenses & Miscellaneous.500.00 Surplus.800.00 $17,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 15, 1953. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1953, Vol.86, No.33 2547 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que la Commission conjointe de l'Industrie de la Robe de la province de Québec, établie en exécution du décret numéro 3519, du 24 septembre 1940, et amendements, a été autorisé par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro* 913 du 6 août 1953, section \"A\" le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus dé Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er août 1953 au 31 juillet 1954; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 3519 doivent verser à la Commission conjointe une somme équivalente à }/2 de 1% des salaires et autres rémunérations payés à leurs salariés.' 6) Les salariés régis par le décret doivent verser à la Commission conjointe une somme équivalente à y% de 1% de leur salaire et autres rémunérations.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, la Commission conjointe met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport indiquant les heures de travail, l'argent perçu au cours de la semaine et les sommes versées à la Commission conjointe.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés à la Commission conjointe tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes qui reviennent à la Commission conjointe.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé à la Commission conjointe.Cette commission a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'elle le juge à propos.Le rapport accompagné des cotisations dues, doit être adressé à la Commission conjointe le ou avant le 10 du mois suivant celui pour lequel ledit rapport est exigible.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, la Commission conjointe doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre ei 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et déboursés prévus de la Commission conjointe de l'Industrie de la Robe de la Province de Québec pour la période comprise entre le 1er août 1953 et le 31 juillet 1954.Recettes et dépenses probables de la Commission conjointe de la Robe de la Province de Québec Pour la période comprise entre le 1er août 1953 et le 31 juillet 1954.NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that he Joint Commission for the Dress Industry of the Province of Quebec, established under decree number 3519, of September- 24, 1940, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 913 of August 6 1953, part \"A\" pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree, according to the method à*nd rate hereinafter mentioned : 1.Levy The period of levy shall extend from August 1, 1953 to July 31st, 1954.Such levy shall be imposed as hereinafter mentioned: a) Professional employers governed by the decree shall pay to the Joint Commission a sum equivalent to one-half of.one percent i}/2 of 1%) of wages and other remuneration paid to ther employees.b) Employees governed by the decree shall pay to the Joint Commission a sum equivalent to one-half of one percent (j^ of 1%) of their wages and other remuneration.2.Mode of Collection In order to facilitate the collection of such assessments the Joint Commision shall supply the professional employers with- printed forms indicating the hours of labour, the money received during the current week, and the sums sent to the Joint Commission.Professional employers shall see to it that these reports be completed and returned to the Joint Commission every month.Professional employers shall collect at the end of each week, from the wages of each employee, the sums payable to the Joint Commission.The report of each professional employer shall be duly signed before it is sent to the Joint Commission.This commission has the right to exact a sworn report when deemed advisable.The report together with all assessments due, shall be sent to the Joint Commision on or before the 10th day of each month following the month for which said report is requirable.3.Financial report According to the Collective agreement Act, the Joint Commission shall send a quaterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.Hereto- annexed is an estimate of the receipts a*nd expenses of the Joint Commission for the Dress Industry of the Province of Québec, for the period between August 1, 1953 and July 31st, 1954.Budget or estimate of receipts and expenses of the joint commission* for the Dress Industry of the Province of Quebec For the period comprised between August 1st 1953 to July 31st, 1954. 254S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.15 août 1953, Tome 85, N° 33 Revenu probable: Basé sur 11,000 salariés, au salaire moyen de 30.00 par semaine, pour 38 semaines approximativement $12.040.000.00 comme suit: Cotisation des salariés, */> de 1 %.$02.700.00 Cotisation des employeurs professionnels, Y2 de 1%.02.700.00 Revenu provenant de placements.2.700.00 12S.100.00 Dépenses probables: Salaires: Administration.20,350.00 Inspecteurs.c.42,000.00 Bureau.'.27,000.00 S9.350.00 Déboursés en général: Entretien de l'édifice, taxes, assurance 15,000.00 Papeterie, impressions et frais de poste.5.000.00 Frais légaux et de vérificat ion.5,000.00 Téléphone et électricité.1.500.00 Frais de déplacements des Inspecteurs.:.5.000.00 Assurance chômage.1.000.00 Dépenses des délégués.250.00 Dépenses générales.5.000.00 Dépréciation: ameublement et agencement.:.1.000.00 38,750.00 I2S.100.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.35370-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes (pie le Comité paritaire de l'Automobile des Cantons de l'Est, établi en exécution du décret numéro 828 du 10 juillet 1953, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 913 du 0 août 1953.section \"C\", et ce conformément aux dispositions de la I.oi de la convention collective (Statuts redondus de Québec, 1941, chapitre 103), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant le mode et le taux ci-après: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 25 juillet 1954; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné.a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 828 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret\".b) Les artisans régis par ledit décret numéro 828 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, ($50.35 par semaine) soit S0.2S par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 828 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yz de 1% de leur rémunération.Est imatcd income : Based on 11,000 employees, each earn- ing an average of 830.00 per week for 38 weeks, approximately $12,' 540,000 as follows: Employees Assessment \\i of 1 %.02,700.00 Professionnal Employers Assessment Y>ot\\%.02,700.00 Income from Investments.2,700.00 128,100.00 * Est i m a ted cvpen ses: Salaries: Administration.20,350.00 Inspections.42,000.00 Office.27.000.00 89,350.00 Overhead: Building Maintenance, Taxes, Insurance.15.000.00 Stationery.Printing & Postage.5,000.00 Legal & Auditing.5,000.00 Telephone & lighting.1,500.00 Inspectors Travel Expenses.5,000.00 Representatives Expenses.250.00 I 'nemployment Insurance.1,000.00 ( ieneral Expenses.5.000.00 Depreciation.Furniture & Fixture.1,000.00 38,750.00 128,100.00 GERARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 15, 1953.35370-u NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Automobile Industry of the Eastern Townships, formed under decree number 828 of July Hi, 1953, has been authorized by a by-law approved by Order-in-Council number 913 of August 0, 1053 part \"C\" in pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 103 as amended), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy shall extend from the date of publication of this by-law in the Quebec Official Gazette to July 25, 1954; such levy to be laid as follows: o) The professional employers governed by the said decree, number S28, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to,ty> of 1% of their payroll for the employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the said decree, number 828, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to J/> of 1% of the lowest wages established in the decree for journeymen, (S5G.35 per week) 80.28 per week.c) The employees governed by the said decree, number 828, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yz of 1% of their remuneration. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1958, Vol.85, No.88 2549 2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur les quelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son'rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes \u2022 payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermcntation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention co.lec-tive, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie de l'Automobile des Cantons de l'Est, pour la période comprise entre le 25 juillet 1953 et le 25 juillet 1954.le comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est Terrasse Pacifique, Sherbrooke, P.Q.État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 25 juillet 1953 et le 25 juillet 1954.Recettes: Cotisations (Y de 1%): Employeurs professionnels.§3,300.00 Artisans.250.00 Salariés.3,300.00 Honoraires d'examen.100.00 Recettes diverses.50.00 §7,000.00 Déboursés: Salaires: Administration, bureau et inspection .§4,600.00 Frais de déplacement Inspection.560.00 Administration.200.00 Loyer du bureau.400.00 Frais légaux.100.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone télégrammes.300.00 Ameublement et accessoires de bureau .175.00 2.M ode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete and sign his report, and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the lattcr's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 15th day of the month following the date of expiration of the period for which it is exigible.The said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments imposed under the present by-law arc payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, he shall be given five days' notice to fulfil his obligation towards the Parity Committee.¦ 3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial activities to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Automobile Industry of the Eastern Townships for the period comprised between July 25, 1953 and July 25, 1954.The Joint Committee of the Automobile of the Eastern Townships Terrasse Pacific, Sherbrooke, P.Q.Estimate of the receipts and disbursements for the period between July 25, 1953 and July 25, 1954.Receipts: Assessments of 1%): Professional employers.83,300.00 Artisans.250.00 Employees.3,300.00 Examination fees.100.00 Miscellaneous.50.00 S7,000.00 Disbursements: Salaries: Administration, inspection and Office employees.4,600.00 Travelling expenses: Inspection.560.00 Administration.200.00 Office rent.400.00 Legal fees.100.00 Stationery, printing, postage, telephone and telegrams.300.00 Office equipment.175.00 2550 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1963, Tome 86, N° 88 Vérification des livres.90.00 Assurance et frais de cautionnement.25.00 Frais de déplacement du président et des membres.100.00 Jetons de présence.200.00 Taxes d'affaires et autres.30.00 Bureau d'examinateurs.100.00 Dépenses diverses et imprévus.120.00 S7.000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.35370-o Audition.90.00 Insurance and fidelity bond.35.00 Travelling expenses of president and members.100.00 Business and other taxes.30.00 Meeting expenses.200.00 Board of Examiners.100.00 Various and unforeseen expenses .120.00 $7,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 15, 1953.35370-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de détail dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 3205 du G septembre 1940, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° En remplaçant, à l'article III, les deux premiers alinéas du pragraphe \"b\" par les suivants : \"b) La semaine régulière de travail dans les établissements régis par le présent décret, sera de 45 heures réparties comme suit: i.de 9.00 a.m., à 5.30 p.m., les lundi, mardi, mercredi et jeudi; ii.de 9.00 a.m., à 9.30 p.m., le vendredi et la veille des jours chômés, à l'exception des mois de juillt et août durant lesquels le travail devra cesser à 5.30 p.m.iii.de 9.00 a.m., à 6.00 p.m.le samedi.2° En remplaçant au paragraphe \"d\" de l'article III, la première phrase de l'alinéa comme suit: \"En aucun temps l'employeur ne pourra faire travailler ses salariés à la vente en dehors de l'horaire mentionné au paragraphe \"b\" ci-haut, si ce n'est pendant la période des fêtes, soit 4 jours ouvrables avant le 24 décembre en plus du vendredi soir et ce jusqu'à 9.30 du soir.\" 3° En remplaçant aux paragraphes \"/\" \"g\" et \"1\" de l'article III les mots \"cinquante (50) heures\" par les mots \"quarante-huit (48) heures.\" 4° En remplaçant, au paragraphe \"k\" de l'article III les mots \"quatre-vingt-quatre (84) heures\" par les mots \"soixante et douze (72) heures\".5° En ajoutant, à l'article III, le paragraphe \"o\" comme suit: \"o) Absence motivée: Tout employé régulier qui aura été à l'emploi continu d'un employeur pendant au moins un an, aura droit à un congé sans retenue de salaire dans les cas suivants: i.de 3 jours à l'occasion du décès de son père, de sa mère, de son conjoint ou de ses enfants; ii.de une journée à l'occasion de la naissance d'un enfant; iii.une journée à l'occasion du mariage d'un enfant.L'enployeur accordera en outre, si les besoins de l'organisation le permettent, les congés nécessaires sans rémunération, au délégué désigné par NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the retail trade in the region of Quebec rendered obligatory by the decree number 3265 of September 6, 1940 have submitted to him a petition to amend the said decree in the following manner: 1.The first two paragraphs of subsection \"6\" of section III will be replaced by the following: \"b) The standard work week in establishments governed by the present decree shall consist of forty-five (45) hours distributed as follows: 1.from 9.00 a.m.to 5.30 p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday; ii.from 9.00 a.m.to 9.30 p.m.on Friday and holiday eves, except for the months of July and August where work shall cease at 5.30 p.m.iii.from 9.00 a.m.to 6.00 p.m.on Saturday.2.The first sentence of subsection \"d\" of section III \"will be replaced by the following: \"The employer shall never cause sales work to be done by his employees beyond the hours mentioned in subsection \"6\" of this section except for the holidays period, i.e.4 working days before December 24, not counting Friday evening, where sales work may be done until 9.30 p.m.\" 3.The words \"fifty (50) hours\" mentioned in subsections \"/\" \"g\" and \"I\" of section III will be replaced by the words \"forty-eight (48) hours\".4.The words \"eighty-four (84)\" mentioned in subsection \"k\" of section III will be replaced by \"seventy-two (72)\".5.The following subsection \"o\" will be added to section III: \"o) Justifie! absence: Every regular employee who has been in the continuous employ of an employer for at least one year is entitled to a holiday without lose of pay in the following cases: i.three (3) days in the event of the decease of his father, mother, wife (or husband) or children; ii.one (1) day in the event of the birth of a child; iii.one (1) day in the event of the marriage of a child.The employer shall also grant, if possible and when authorized by his director of personnel holidays without pay to the representative desi, / QVEBEC10FFICÎAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1963, Vol.86, No.83 2551 le Sunxlicat, pour assister au congrès annuel d'une organisation auquel il est affilié, sur autorisation préalable du directeur du personnel de l'employeur.6° A l'article IV, en corrigeant les taux de salaire par les suivants: \"Occupations: Salaires hebdomadaires hommes femmes à) cbef de rayon : Dans département faisant $100,000 d'affaires et plus $03.00 $48.00 dans département faisant $50,000 d'affaires et plus: 58.00 42.00 Dans département faisant moms de $50,000.d'affaires.53.00 37.00 b) chef étalagiste.58.00 c) chef d'allée.47.00 46.00 d) comptable.53.00 préposé à la perception extérieure.39.00 e) Commis: taux horaires 1° surnuméraires.0.75 0.50 2° supplémentaires.0.85 0.60 3° régulier: par semaine durant la le année d'ex- , périence.18.50 17.00 durant la 2e année d'expérience.22.50 20.00 durant la 3e année d'expérience.26.00 22.50 durant la 4e année d'expérience.30.50 durant la 5e année d'expérience .34.50 Tous les employés féminins de cette, catégorie ayant trois années d'expérience ou plus doivent être payées comme suit: 1/3 classe C.20.00 1/3 classe B.28.00 1/3 classe A.31.00 Tous les employés masculins de cette catégorie ayant cinq (5) années d'expérience ou plus doivent être payés comme suit: 1/3 classe C.41.00 1/3 classe B.45.00 1/3 classe A.50.00 Etalagiste: Classe A.53.00 Classe B.46.00 Classe C.43.00 5.Employés de bureau: Durant 1ère année d'expérience.20 00 18 00 Durant 2ème année d'expérience.24.00 22.00 Durant 3è année d'expérience .27.00 24.00 Durant 4è année d'expérience.31.00 Durant 5è année d'expérience .35.00 Tous les employés féminins de cette catégorie ayant trois années d'expérience ou plus doivent être pavées comme suit: 1/3 classe C.28.00 1/3 classe B.30.00 1/3classe A.32.00 Tous les employés masculins de cette catégorie ayant cinq années d'expérience ou plus doivent être payés comme suit: 1/3 classe C.42.00 1/3 classe B.46.00 1/3 classe A.51.00 gnated by the Union to attend the annual congress of an organization to which it is affiliated.6.In section IV, the rates of wages shall be corrected as follows: \"Occupations: Weekly Wages Male female a) Departmental manager: With a minimum turnover in his department of $100,000.00.$63.00 $48.00 With a minimum turnover of $50,000.00 .58.00 42.00 Whose turnover is lesss than $50,000.00 .53.00 37.00 b) Head displayer.58.00 c) Floor-walker.47.00 46.00 d) Accountant.53.00 Collector (outside).39.00 e) Clerk: per hour 1.Supernumerary employee.$ 0.75 $ 0.50 2.Extra employee.0.85 0.60 3.Regular employee : per week During 1st year of experience.s.*.18.50 17.00 During 2nd year of experience.:.22.50 20.00 During 3rd year of experience.26.00 22.50 During 4th year of experience.30.50 During 5th year of experience.34.50 All female employees in this category with three (3) years of experience or more shall be paid as folios: 1/3 Class C.20.00 1/3 Class B.28.00 1/3 Class A.31.00 All male employees in this category with five years of experience or more shall be paid as follows: 1/3 Class C.41.00 1/3 Class B.'.45.00 1/3 Class A.50.00 Displayers: Class A.53.00 Class B.;.46.00 Class C.43.00 5.Office employee: During 1st year of experience.20.00 18.00 During 2nd j?ear of experience.24.00 22.00 During 3rd year of experience.27.00 24.00 During 4th year of experience.31.00 During the 5th year of rience.35.00 All female employees of this category with three (3) years of experience or more shall be paid as follows: 1/3 Class C.28.00 1/3 Class B.30.00 1/3 Class A.32.00 All male employees of this category with five (5) years of experience or more shall be paid as follows: 1/3 Class C.42.00 1/3 Class B.46.00 1/3 Class A.51.00 2552 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 195S, Tome 86, N° 88 f) Autres employés: r Livreur.44.00 Aide-livreur de moins de 21 ans, durant lè année d'ex- année\td'ex- année\td'ex- année\td'ex- année\td'ex- Aide-livreur de 21 ans et plus.38.00 2° Messager.17.00 3° Chasseur.14.00 g) Personnel d'atelier: 1° Homme: par semain i) apprenti-tailleur ou couturier: 1ère année.18.50 2ème année.21.00 3ème année.24.00 4ème année., 28.00 5ème année.32.00 ii) Les tailleurs ou couturiers ayant cinq ans d'expérience ou'plus doivent être rémunérés comme suit: 1/3 classe C.38.00 1/3 classe B.43.00 1/3 classe A.49.00 2° Femme: i) apprentie modiste ou couturière 1ère année.17.00 2ème année.20.00 3ème année.____ 22.50 ii) Les modistes-couturières ayant trois années d'expérience ou plus doivent être rémunérées comme suit: 1/3 classe C.26.00 1/3 classe B.28.00 1/3 classe A.32.00 i) Les hommes de métiers détenteurs d'une carte de compagnons, émises par le Comité Paritaire, doivent être rémunérés au taux -de 850.00 par semaine.j) Les apprentis de métiers devront recevoir les salaires suivants: Apprenti 1ère année.17.00 Apprenti 2ème aimée.20.00 Apprenti 3ème année.22.00 Apprenti 4ème année.28.00 10 Hommes d'ouvrage général: a) de moins de 21 ans: durant lè année d'expérience.: :.19.00 durant 2è année d'expérience.23.00 durant 3è année d'expérience.26.00 durant 4è année d'expérience.'.30.00 durant 5è année d'expérience.34.00 b) de 21 ans et plus.38.00 c) travaillant en dehors des heures régulières de travail soit entre 0.00 p.m.et 8 a.m.0.70 l'heure 2° Femmes de ménage: pour 48 heures de travail par semaine, fait de jour ou de nuit.24.00 travaillant moins de 35 heures par semaine.0.55 l'heure /) Other employees: 1.Delivery man.44.00 Delivery man's helper under 21 years of age: During 1st year of experience.19.00 During 2nd year of experience.23.00 During 3rd year of experience.26.00 During 4th year of experience .30.00 During 5th year of experience .34.00 Delivery man's helper, 21 years or more.38.00 2.Messenger.17.00 3.Errand boy.14.00 g) Shop staff: 1.Male employees: per week i) Apprentice-tailor or dres- maker: .1st year.18.50 2nd year.21.00 3rd year.24.00 4th year.28.00 5th year.32.00 ii) Tailors and dress-makers with 5 years of experience or more shall be paid as follows: 1/3 Class C.$38.00 1/3 Class B.43.00 1/3 Class A.49.00 2.Female employees: i) Apprentice-milliner or seamstress: 1st year.17.00 2nd year.20.00 3ndyear.22.50 ii) Milliners and seamstress with 3 years of experience or more shall be paid as follows: 1/3 Class C.26.00 1/3 Class B.28.00 1/3 Glass A.32.00 i) Tradesmen holding a journeyman's card issued by the Parity Committee, shall be remunerated at the rate of $50.00 per week.j) Trade apprentices shall receive the following wages: Apprentice, 1 st year.$ 17.00 Apprentice, 2nd year.20.00 Apprentice, 3rd year.22.00 Apprentice, 4th year.28.00 1.General work employees: a) under 21 years of age: during 1st year of experience.19.00 during 2nd year of experience.23.00 during 3rd year of experience.26.00 during 4th year of experience.30.00 during 5th year of experience.34.00 6) 21 years of age or more.38.00 c) working outside the regular working hours, i.e.between 6.00 p.m.and 8.00 a.m.$0.70 per hour 2.Charwoman: for 48 hours of work per week, day or night.24.00 working less than 35 hours per week.$0.55 per hour QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1953, Vol, 85, No.33 2553 3° Préposés aux ascenseurs: pour 45 heures de travail.18.50 l) Le salaire hebdomadaire des gardiens de nuit sera comme suit: o) gardien de nuit faisant seulement de la surveil- \\ lance.35.00 b) gardien de nuit qui fait de l'ouvrage général.42.00 7° En radiant le paragraphe 'V de l'article IV.8° Le paragraphe 'V deviendra le paragraphe \"to\" et les taux de salaire seront remplacés par les suivants: \"Les salaires payables à ces salariés seront comme suit: filles: 25%.$17.50 50%.19.75 25%.21.71 hommes: 1/3.-.20.25 1/3.24.50 1/3.29.75\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.35370-o 3.Elevator employee: for 45 hours of work.18.50 I) The weekly wage rate of night watchmen shalll be as follows: a) night watchman committed to the watch only 35.00 /;) night watchman doing general work.42.00\" 7.Subsection \"to\" of section IV will bè**deleted 8.Subsection \"x\" will become subsection \"to\" and the wage rates will be replaced by the following: \"The minimum wage rates payable to such employees shall be as follows: Female: 25%.$17.50 50%.19.75 25%.21.75 Male: 1/3.20.25 1/3.24.50 1/3.29.75\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August, 15, 1953.35370-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier et coiffeur dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 2162 du 20 août 1941, lui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, de la façon suivante: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article IV sera remplacé par le suivant: \"a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés: Pour chaque compagnon barbier-coiffeur régulier: trente-trois dollars ($33.00) par semaine, plus une commission de 50% sur les recettes de son travail excédant quarante-trois dollars $.00) par semaine.Pour chaque compagnon barbier-coiffeur surnuméraire: $0.85 pour chaque heure de travail, plus une commission de 10% sur toutes les recettes brutes de son travail.Toutefois, lorsque les recettes de -son travail atteignent ou excèdent la somme de quarante-trois dollars ($43.00) et que ledit salarié a travaillé pendant trente (30) heures ou plus durant la semaine, il doit être rémunéré au même tarif que le compagnon barbier-coiffeur régulier.\" 2° A l'article V, les prix minima ci-après mentionnés seront substitués à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour chacun des services concernés, à savoir: \"Coupe de cheveux pour adultes des deux sexes: Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.$0.70 Coupe de cheveux pour adultes des deux .sexes: Les samedi et veilles des fêtes chômées spécifiées dans le présent décret.0.80 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber's and hairdressers' trades in the region of Montreal, rendered obligatory by the decree number 2162 of August 20, 1941, have submitted to him a petition to amend the said decree, as amended, as follows: 1.Subsection \"a\" of section IV will be replaced by the following: \"a) The maximum rates of wages shall be as follows: For every regular journeyman barber-hairdresser, thirty-three dollars ($33.00) per week plus a 50% commission on the receipts of his work exceeding forty-three dollars ($43.00) per week.For every occasional journeyman barber-hairdresser: $0.85 per hour plus a 10% commission on the gross receipts of his work.However, when the receipts of his work attain or exceed the amount of forty-three (43.00) dollars and when the said employee has worked a minimum of 30 hours during the week, he shall be paid the rate of the regular journeyman barber-hairdresser.\" 2.In section V, the minimum prices hereafter mentioned will be substituted for those actually mentioned in the decree for each one of the services concerned, namely: \"Haircut for adults, male and female: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.$0.70 Haircut for adults, male and female: Saturday and eves of holidays mentioned in the present decree.0.80 2554 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1953, Tome 35, N° 33 Coupe de cheveux pour enfants des deux sexes de moins de 15 ans: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.45 Coupe de cheveux pour enfants des deux sexes de moins de 15 ans: Les vendredi, samedi et veilles des fêtes chômées spécifiées dans le présent décret.0.55\" 3° Le paragraphe \"o\" de l'article VI sera remplacé par le suivant: \"o) Le salaire hebdomadaire de l'apprenti est le suivant: Du 4ème au 6ème mois d'apprentissage, ou de la sortie du Centre d'Apprentissage au 6ème mois: $16.00 par semaine; Deuxième semestre: $19.00 par semaine, plus 10% de commission sur les recettes supérieures à $29.00; Troisième semestre: $22.00 par semaine, plus 20% de commission sur les recettes supérieures à $32.00; Quatrième semestre: $25.00 par semaine, plus 30% de commission sur les recettes supérieures à $35.00; Cinquième semestre: $28.00 par semaine, plus 40% de commission sur les recettes supérieures à $38.00; Sixième semestre: $32.00 par semaine, plus 50% de commission sur les recettes supérieures à $42.00.\" 4° L'article VHJ-A sera remplacé par le suivant: \"VTII-A.Vacatwes payées: Les employeurs devront donner une semaine de vacances payées, au taux de trente-six (36.00) dollars, à tout compagnon barbier-coiffeur régulier qui a été en service pendant une amiée entière, sans perte de temps, sauf pour des raisons valables.Au cas où le compagnon barbier-coiffeur aurait servi moins d'ime année, il aura droit à une rémunération de vacances de 1/12 du salaire de trente-six ($36.00) dollars pour chaque mois de service sans perte de temps, sauf pour des raisons valables.L'employeur devra domier une semaine de vacances payées à tout apprenti ayant été en service pendant une année.Le taux de salaire-vacances pour l'apprenti sera celui auquel il a droit à la date d'échéance de ses vacances; toutefois, lorsque l'apprenti aura servi moins d'une année, il aura droit à 1/12 de son salaire de base pour chaque mois de service sans perte de temps, sauf pour des raisons valables.Lorsqu'un employeur se trouve dans l'impossibilité de trouver un remplaçant à un compagnon barbier-coiffeur pour la durée de ses vacances, il lui sera permis, avec le consentement des parties et du Comité paritaire, de remplacer la semaine de vacances par un boni égal au taux de salaire de vacances.Pour chaque congé annuel pris et payé, ou remplacé par un boni, l'année de service d'un salarié s'établit à compter de la date de son entrée en service pour le même employeur.Dans le cas de vente ou de transfert d'un salon de barbier, le nouveau propriétaire et employeur assume toutes les obligations de l'employeur précédent envers tout compagnon barbier-coiffeur régulier ou apprenti relativement aux vacances payées.L'employeur doit faire connaître au salarié, au moins deux (2) semaines à l'avance, la date fixée pour ses vacances; la rémunération de vacances est payable avant le départ pour la semaine de vacances.\" Haircut for children, male and female, under 15 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.45 Haircut for children, male and female under 15 years of age: Friday, Saturday and eves of holidays mentioned in the present decree.0.55\" 3.Subsection \"o\" of section VI will be replaced by the following: \"o) The weekly wages of apprentices shall be as follows: From the 4th to the 0th month of apprenticeship, or from the/time the apprentice leaves the apprenticeship center to the 6th month: $16.00 per week; Second six moths: $19.00 per week plus 10% commission on receipts exceeding $29.00; Third six months: $22.00 per week plus 20% commission on receipts exceeding $32.00; Fourth six months:-$25.00 per week phis 30% commission on receipts exceeding $35.00; Fifth six months: $28.00 per week plus 40% commission on receipts exceeding $38.00; Sixth six months: $32.00 per week plus 50% commission on receipts exceeding $42.00.\" 4.Section VIII-A will be replaced by the following: \"VIII-A.Vacation with pay: The employers (barbers-hairdressers) shall give a vacation of one week with pay, at the rate of thirty-six dollars ($36.00), to every regular barber-hairdresser journeyman who has been a whole year in his employ, without loss of time, except for good reasons.In the event that a journeyman barber-hair-dresser has worked less than one year, he is entitled to a vacation pay of 1/12 the wages of thirty-six ($36.00) dollars for each month of service without loss of time, except for good reasons.The employer shall give a week of vacation with pay to every apprentice with one year of service.The rate of vacation pay for the apprentice shall be that to which he is entitled at the date of his vacation; however, when the apprentice has had less than one year of service, he is entitled to 1/12 of his basic wages for each month of service without loss of time, except for good reasons.When an employer is unable to replace a journeyman barber-hairdresser for the duration of his vacation, he may, with the consent of the parties and of the Parity Committee, replace the vacation week by a bonus equal to the vacation pay.» For every annual vacation taken and paid, or replaced by a bonus, the year of service of an employee is computed from the date of employment by the same employer.\" In the event of the sale or transfer of a barber-hairdresser parlor the new owner and employer assumes the duties of the previous employer towards every regular journeyman barber-hairdresser or apprentice as regards vacation with pay.The employer shall notify the employee, at least two (2) weeks in advance, of the date of his vacation; vacation pay is payable before the vacation.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1953, Vol.85, No.33 2555 Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY Ministère du Travail, Québec, le 15 août 1953.35370-o During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 15, 1953.35370-o Index de la Gazette officielle de Qiébec, N* 33 Action en séparation de biens: Poulin vs Rodrigue.2519 Arrêté en Conseil: 916 \u2014 Concernant l'abrogation du règlement N° 15 de la Commission des accidents du travail de Québec et son remplacement par le règlement N° 19 de la dite Commission.2520 Avis aux intéressés: 2501 réception des annonces: 2501 Avis divers: Capucins, munie, de (Changement de nom).2521 Chanbay Limited .(Dist.de l'actif).2521 Chantier Coopératif de l'U.C.C.Que-bec Sud (Fondation).2520 Coopérative de Charlesbourg (Fondation) .2523 David & Frère, Limitée (Directeurs).2522 Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.(règlements).2523 La Caisse d'Economie Alrol Credit Union (Fondation).2522 La Caisse Populaire de St-Camille (Fondation).2522 Lake Brûlé Country Club Limited (Directeurs).2521 Les Presses Laurentiennes (Fondation).2523 Le Syndicat des Producteurs-Fournis-seufs de Lait de la Laiterie Ste-Mar-guerite (Formation).2521 United Customs Brokers Limited (Directeurs) .2523 Chartes \u2014 Abandon de: Centre Colombien Limitée.2524 Harry S.Oakes Incorporated.2524 La Compagnie de Publication du Nou- velliste,Limitée.2524 Le Nouvelliste Limitée.^525 Service Contracting Company Limited.2524 Valley Flax Products Ltd.2524 Compagnie autorisée a faire des affaires: J.& E.Hall Limited.2525 DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Affaires Municipales: Concernant l'émission des lettres patentes érigeant la ville de Murdoch-vill (Correction).'.\u2022 \u2022 2525 Index of the Quebec Official Gazette, No.33 Action for Separation as to Property : Poulin vs Rodrigue.2519 Order in Council: 916 \u2014 Concerning the repeal of By-law No.15 of the Quebec Workmen's Compensation Commission and its replacement by By-law No.19 of the said Commission.2520 Notice to Interested Parties: 2501 Receipt of Advertising Copies: 2501 Miscellaneous Notices: Capucins, munie, of (Change of name).2521 Chanbay Limited (Dist.of the assets).2521 Chantier Coopératif de l'U.C.C.Québec Sud (Foundation).2520 Coopérative de Charlesbourg (Foundation) .2523 David & Frère, Limitée (Directors).2522 Fédération des Oeuvres de Charité Canadiennes-Françaises, Inc.(By-Laws).2523 La Caisse d'Economie Alrol Credit Union (Foundation).2522 La Caisse Populaire de St-Camille (Foundation).2522 Lake Brûlé Country Club Limited (Directors).;.2521 Les Presses Laurentiennes (Foundation) 2523 Le Syndicat des Producteurs-Fournisseurs de Lait de la Laiterie Ste-Mar-guerite (Formation).2521 United Customs Brokers Limited (Di-\u2022 rectors).2523 Charters \u2014 Surrender of: Centre Colombien Limitée.2524 Harry S.Oakes Incorporated.2524 La Compagnie de Publication du Nouvelliste, Limitée.2524 Le Nouvelliste Limitée.2525 Service Contracting Company Limited.2524 Valley Flax Products Ltd.2524 Company Licensed to do Business: i J.& E.Hall Limited.2525 DEPARTMENTAL NOTICES: Municipal Affairs: Concerning the issuance of the letters patent erecting the town of Murdoch-ville (Correction).2525 2556 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1958, Tome 86, N° 33 Agriculture: Industrie laitière: Agriculture: Dairy Industry: Ordonnance N° 23-51A \u2014 Berthierville.2526 Order No.23-51A \u2014 Berthierville.2526 Instruction' publique: Municipalité scolaire de: Education: School Municipality of: Gaspé (Protestante).Lacolle (Protestante) .Newport.Newport.Pointe-aux-Chêncs.Rouyn (Erratum).St-Gcorges-de-Bcauce.St-Paul-de-Châteauguay.St-Sylvestre.2528 2529 2527 2526 2526 2528 2527 2527 2527 Gaspé (Protestant).Lacolle (Protestant).Newport.Newport.Pointe-aux-Chêncs.Rouyn (Erratum).St-Georges-dc-Beauce.St-Paul-de-Châteauguay.St-Sylvestre.Travail: Industrie ou métiers de: Automobile des Cantons de l'Est (Prélèvement) .Automobile des Cantons de l'Est (Règlements) .: Barbier et coiffeur de Montréal (Modification).Commerce de détail de Québec (Modification) .Construction de Québec (Règlements).Fabrication du métal en feuille (Prélèvement) .\u2022.Fabrication du métal en feuille (Règlements) .\" Robe, p.de Québec (Prélèvement) .Lettres patentes: B.E.Leclerc & Fils Ltée.Besmetal Industries Inc.Cancer Aid League Inc.Club de Croquet de Belœil Inc.Colger Ltd.Continental Automobiles Inc.Custom Packaging Limited.Cypress Lumber Co.Ltd.Dalco Realties Limited.Dominion Television and Appliance Company Limited.Economic Finance Corporation.Ferronnerie Robert Hardware Inc.Formcraft Fabrics Co.Limited.Goldmark Optical Supplies Ltd.H.L.Singer Co.Industrial Accessories Ltd.John Brooks & Company Limited .J.P.Morin Ltée.Labrador Ungava Explorations Ltd.La Ligue des Propriétaires du Quartier St-Jean Baptiste de St-Joseph de Sorel.La Maison Dominion Ltée.Les Constructions Saint-Jean Limitée \u2014 St.Johns Constructions Limited.Metropolitan Factors Corporation.Millcrev Holdings Ltd.Modem Finance Company Limited .National Auto Body Co.Ltd.National Beef Inc.National Boiler Works Co.Ltd.Paris Canada Films (Quebec) Inc.Phil Himes Mfg.Inc.Scandia Supply Co.Ltd.Société Zoologique de Granby Inc.Staplecraft Company Inc.\u2022 .St.Michael's Dry Gleaners Limited.Stork Shops Inc.Valois Youth Recreational Association.Labour.: Industry or Trades of: Automobile of the Eastern Townships (Levy).Automobile of the Eastern Townships (By-Laws).Barber's and hairdresser's of Montreal (Amendment).Retail trade of Quebec (Amendment).Construction of Quebec (By-Laws).Sheet metal fabricating (Levy).Sheet metal fabricating (By-Laws)- Dress, P.of Quebec (Levy).Letters Patent: B.E.Leclerc & Fils Ltée.Besmetal Industries Inc.Cancer Aid League Inc.Club de Croquet de Beloeil Inc.Colger Ltd.Continental Automobiles Inc.Custom Packaging Limited.Cypress Lumber Co.Ltd.Dalco Realties Limited.Dominion Television and Appliance Company Limited.Economic Finance Corporation.Ferronnerie Robert Hardware Inc.Formcraft Fabrics Co.Limited.Goldmark Optical Supplies Ltd.H.L.Singer Co.'.Industrial Accessories Ltd.John Brooks & Company Limited .J.P.Morin Ltée.Labrador Ungava Explorations Ltd.La Ligue des Propriétaires du Quartier St-Jean Baptiste de St-Joseph de 2510 Sorel.f.2511 La Maison Dominion Ltée.Les Constructions Saint-Jean Limitée 2511 \u2014 St.Johns Constructions Limited.2511 Metropolitan Factors Corporation.2512 Millcrev Holdings Ltd.2512 Modern Finance Company Limited .2512 National Auto Body Co.Ltd.2513 National Beèf Inc.2513 National Boiler Works Co.Ltd.2513 Paris Canada Films (Quebec) Inc.» 2514 Phil Himes Mfg.Inc.2514 Scandia Supply Co.Ltd.2514 Société Zoologique de Granby Inc.2515 Staplecraft Company Inc.;.2515 St.Michael's Dry Cleaners Limited.2515 Stork Shops Inc.2516 Valois Youth Recreational Association.2548 2545 2553 2550 2544 2545 2545 2547 2502 2503 2503 2504 2505 2505 2505 2500 2500 2500 2507 2507 2508 2508 2508 2509 2509 2509 2510 2528 2529 2527 2520 2520 2528 2527 2527 2527 2548 2545 2553 2550 2544 2545 2545 2547 2502 2503 2503 2504 2505 2505 2505 2500 2506 2506 2507 2507 2508 2508 2508 2509 2509 2509 2510 2510 2511 2511 2511 2512 2512 2512 2513 2513 2513 2514 2514 2514 2515 2515 2515 2516 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1953, Vol.86, No.83 2557 Wasacz Construction Co.Ltd.2516 Wasacz Construction Co.Ltd.2516 Wilfrid Lévesque Incorporé.2516 Wilfrid Lévesque Incorporé.2516 Windsor Dress Co.Ltd.2517 Windsor Dress Co.Ltd.2517 Lettres patentes supplémentaires: Supplementary Letters Patent: F.J.Raskin Incorporée.2517 F.J.Raskin Incorporée.2517 Food Products Limited.2517 Food Products Limited.2517 International Plumbing and Heating International Plumbing and Heating Supplies Limited.2518 Supplies Limited.2518 Lord & Cie Limitée.2518 Lord & Cie Limitée.2518 Peel Investment Corporation.2578 Peel Investment Corporation.2578 Salon Astrid Limitée.2518 Salon Astrid Limitée.2518 Stanley Bagg Corporation.2519 Stanley Bagg Corporation.2519 The Callway Sash and Door Incorpo- The Callway Sash and Door Incorporated.2519 rated.2519 Tilden Rent-A-Car Company.2519 Tilden Rent-A-Car Company.2519 Ministère des Finances: Department of Finance: Assurances: Insurance: Canadian Reinsurance Company.2530 Canadian Reinsurance Company.2530 The Order of Italo-Canadians et al.2530 The Order of Italo-Canadians etal .2530 Sièges sociaux: Head Offices: Lambert & Gelinas Ltée \u2014 Lambert & Lambert & Gelinas Ltée \u2014 Lambert & Gelinas Ltd.2530 Gelinas Ltd.2530 Laterriere Catering Limited.2531 Laterriere Catering Limited.2531 Madeleine Incorporée.2531 Madeleine Incorporée.2531 Troysco Mines Limited.2531 Troysco Mines Limited.2531 United Industrial Suppliers Company - United Industrial Suppliers Company Ltd.2531 Ltd.2531 Soumissions: Tenders: Escoumains, munie, de.2533 Escoumains, munie, of.2533 Malartic, ville de.:.\u2022 \u2022.2532 Malartic, town of.2532 Vente, Loi de faillite: Sale, Bankruptcy Act: Contala, Joseph.2434 Contala, Joseph.2534 Ventes par licitation: Sales by Licitation: Dandavino vs Dandavino et al.2534 Dandavino vs Dandavino et al.2534 Pinard vs Labelle et al.2536 Pinard vs Labelle et al.2536 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Arthabaska: Arthabaska: Léonidos Dion et Fils Ltée, vs Augers.2537 Léonidas Dion et Fils Ltée, vs Augers.2537 Beauce: Beauce: Vaillancourt vs Hébert.2537 Vaillancourt vs Hébert.2537 Beauharnois: Beauharnois: La Maison Blain Limitée vs McRae.2538 La Maison Blain Limitée vs McRae.2538 Bedford: Bedford: Metropolitan Loan Corporation vs Metropolitan Loan Corporation vs Charpentier.2538 Charpentier.2538 Gaspé: Gaspé: Duguay vs Langelier.2539 Duguay vs Langelier.2539 Joliette: Joliette: Bonin vs Beausoleil.2539 Bonin vs Beausoleil.2539 Kamouraska : Kamouraska : Bidegaré et vir vs Pelletier.2540 Bidegaré et vir vs Pelletier.2540 2558 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1958, Tome 86, N° 33 Lavoie vs Bélanger.2540 La voie vs Bélanger.2540 Société Coopérative Agricole de Beur- Société Coopérative Agricole de Beur- rerie vs Gamache.2540 rerie vs Gamache.2540 Labelle: Labelle: Lamoureux vs Thibeault.2541 Lamoureux vs Thibeault.2541 Québec: .Quebec: Gouin vs Gouin.2541 Gouin vs Gouin.2541 Richelieu: Richelieu: Fortin et vir vs Pauly- .2542 Fortin et vir vs Pauly.«, 2542 Rouyn-Noranda: Rouyn-Noranda: ' The Manufacturers Life Insurance Com- The Manufacturers Life Insurance Company vs Robin.2542 pany vs Robin.2542 Ipperciel vs Paradis.2543 Ipperciel vs Paradis.2543 Terrebonne: Terrebonne: Roger vs Jackson.\u2022.2543 Roger vs Jackson.*.2543 35333-0 35333-0 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Pabadis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis.imprimeur de la Reine.Queen's Printer."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.