Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 décembre 1953, samedi 5 (no 49)
[" Tome 85, N° 49 3603 Vol.85, No.49 \t¦\t flHLH\t\t \ti\t \t¦\t* Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Quebec, samedi 5 décembre 1953 AVIS AUX- INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Qazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, December 5th, 1953 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning: but the final delay foi Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, Hw, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.ai second class mailable matter. 3604 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 décembre 1953, Tome 85, N° 19 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre: le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"q\" signifie 3ne la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u2014 1-52 Lettres patentes receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.v First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number: the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion: the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our compositiori nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898 \u2014 1-52 Letters Patent (P.G.47697-53) Acme Asbestos Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du cinq novembre 1953.constituant en corporation: Gérard Beaupré, Marcel Trudeau, Claude Be-noît, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'isolants, sous le nom de \"Acme Asbestos Company Ltd\", avec un capital de $25,000 divisé en 2,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le cinq novembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.(A.G.47697-53) Acme Asbestos Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec.rcprcsented by Mr.C.LaRichelièrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifth day of November, 1953, incorporating: Gérard Beaupré, Marcel Trudeau, Claude Benoît, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in insulation materials under the name of \"Acme Asbestos Company Ltd\", with a capital stock of $25,000 divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of November, 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 5th, 1953, Vol.85, No.49 3605 (P.G.46828-53) Agences Claude Limitée Claude Agencies Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des companies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiehe-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.H.Q., 1941, «les lettres patentes en date du vingt-huit octobre 1953, constituant en corporation: René Roy.commerçant, Claude Picard, avocat, Claude Thouin.vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce (Particles et marchandises faits, en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et tous les sous-produits d'iccux, sous le nom de \"Agences Claude Limitée\" \u2014 \"Claude Agencies Limited\", avec un capital de 840,000 divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 168 est, rue Notre-Dame, dans les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.(P.G.47651-53) Air Operated Equipment and Supplies Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièrc, conformément à l'article 2.chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du trois novembre 1953, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur Daniel Ruby, Lewis Jack Manolson, comptables agréés, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le .commerce comme manufacturiers et marchands de toutes sortes d'outillage, machinerie, appareils et pièces, sous le nom de \"Air Operated Equipment and Supplies Limited\", avec un capital de 820,000 divisé en 150 actions ordinaires de 8100 chacune et 50 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois novembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.(P.G.46401-53) Audit' Théoret Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huit octobre 1953, constituant en corporation: Jean Marien, Pierre Marien, comptables, Guy-E.Boisvert, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme électricien, entrepreneur et commerçant d'appareils électriques, sous le nom de \"André Théorct Compagnie Limitée\", (A.G.4682S-53) Agences Claude Limitée Claude Agencies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the twenty-eighth day of October 1953, incorporating: René Roy, merchant, Claude Picard, advocate, Claude Thouin, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in articles and merchandise made, wholly or partly, of leather, rubber, metal, metalloid, wood, paper, nylon, plastic, fur, fextiles.glass and all by-products thereof, under the name of \"Agences Claude Limitée\" \u2014 \"Claude Agencies Limited\", with a capital stock of 840.000 divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 168 Notre-Dame Street, East, in the city and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-eighth dav of October 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.47651-53) Air Operated Equipment and Supplies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the third day of November 1953, incorporating: Milton Lowen Klein, advocate, Arthur Daniel Ruby, Lewis Jack Manolson, chartered Accountants, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturers and dealers in all kinds of equipment, machinery, appliances and parts, under the name of \"Air Operated Equipment and Supplies Limited\", with a capital stock of 820,000 divided intoloO common shares of $100 each and 50 preferred shares of $100 each.The head office of the Company to be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Gen ral, this third day of November 1953.L.DÉSILETS, 36154-0 Deputy Attorney General.(A.G.46401-53) André Théoret Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelièrc, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eighth day of October, 1953, incorporating: Jean Marien, Pierre Marien, accountants, Guy E.Boisvert, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an electrician, contractor and dealer in electrical apparatus, under the name of \"André Théoret Compagnie Limitée\", 3606 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 décembre 1953, Tome 85, N° 19 avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Geneviève, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit octobre 1953.L*Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.with a capital stock of 840,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sainte-Geneviève, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of October, 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(P.G.47433-53) \u2022 (A.G.47433-53) Ardny Plumbing and Heating Supplies Inc.Arday Plumbing and Heating Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- proyince de Quebec, représenté par M.C.-La- ince of Quebec, represented by Mr.C.LaRi- Richelière, conformément à l'article 2, chapitre chelière, in conformity with section 2, chapter 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day du trentième jour d'octobre 1953, constituant of October 1953, incorporating: Abraham Cohen, en corporation: Abraham Cohen, Bernard S.Bernard S.Mergler, advocates, Muriel Fishman, Mergler, avocats, Muriel Fishman, secrétaire, secretary, all of the City and judicial district tous des cité et district judiciaire de Montréal, of Montreal, for the following purposes: pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce d'appareils To trade and deal in plumbing and heating de plnjnhcric et de chauffage, outillage et accès- fixtures, equipment and supplies, under the name soires, sous le nom de \"Arday Plumbing and of \"Arday Plumbing and Heating Supplies Inc.\", Heating Supplies Inc.\", avec un capital de with a capital stock of 850,000 divided into 200 850,000 divisé en 200 actions ordinaires de 8100 common shares of 8100 each and 300 preferred chacune et 300 actions privilégiées de 8100 shares of $100 each, chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company to be at Montréal, district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General, trentième jour d'octobre 1953.this thirtieth day of October 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 36154 L.DÉSILETS.36154-o Deputy Attorney General.(P.G.46833-53) Armand Magnan Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richclièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trente octobre 1953, constituant en corporation: Armand Magnan, marchand, de Ste-Thérèsc-de-Blainvillc, district judiciaire de Terre-bonne, Yvanhoe Baxter Richer, C.A., comptable, de Montréal, Ignace Joseph Dcslauriers, C.R., avocat, de Wcstmount, tous deux du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme commerçants de combustible et de matériaux de construction, sous le nom de \"Armand Magnan Inc.\",\"avec un capital divisé en 990 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 200 actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Thérèse-dc-Blainville, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général le trente octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.(P.G.47446-53) Berke's Snak Bar Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du septième jour de novembre 1953, constituant en corporation: Jack Lightstone, avocat, Yvonne (A.G.46833-53) Armand Magnan Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of October 1953, incorporating: Armand Magnan, merchant, of Ste-Thérèse-de-Blainville, judicial district of Terrebonne, Ivanhoe Baxter Richer, C.A., accountant, of Montreal, Ignace Joseph Deslauriers, Q.C.advocate, of Wcstmount, both of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as merchants dealing in fuel and building materials, under the name of \"Armand Magnan Inc.\", with a capital stock divided into 990 preferred shares of a par value of $100 each and 200 common shares without nominal value.The head office of the company will be at Ste-Thérèse-dc-Blainvillc, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, the thirtieth day of October 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.47446-53) Berke's Snak Bar Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventh day of November 1953, incorporating: Jack Lights stone, advocate, Yvonne Bélanger, Marjoric QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 5th, 1953, Vol.85, No.Â9 3607 Bélanger, Marjorie Gilbride, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des restaurants, kioskes de rafraîchissements et comptoirs pour repas légers, sous le nom de \"Berke's Snak Bar Ltd.'', avec un capital de §20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce septième jour de novembre 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 36154 C.-E.CANTIN.(P.G.47657-53) Brinton Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordj par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatrième jour de novembre 1953, constituant en corporation: Madeline Ferguson, Marie Poulos, secrétaires, filles majeures, Edward L Auerback, avocat et solliciteur, de Montréal, Lawrence Marks, avocat et solliciteur, de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et faire le commerce d'immeubles et propriétés immobilières, sous le nom de \"Brinton Realty Cor]).\", avec un capital de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de novembre 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 36154 C.-E.CANTIN.(P.G.45559-53) Canadian Ruler, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richclière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-neuvième jour d'octobre 1953, constituant en corporation: Marcel Pigeon, avocat, Edmée Fortin, secrétaire, fille majeure, Lionel Lefebvre, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de règles, tiges à mesurer, calibres, dés pour le golf, boîtes de toutes sortes, verre, drap, celluloide, toutes sortes de marchandises en bois, nouveautés de publicité, crayons, plumes, accessoires d'école et de bureau de toutes variétés, sous le nom de \"Canadian Ruler, Limited\", avec un capital de $40,-000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la ville de Bedford, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-neuvième jour d'octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.Gilbride, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate restaurants, refreshment stands and lunch counters, under the name of \"Berke's Snak Bar Ltd.\", with a capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company to be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November 1953.C.-E.CANTIN.36154-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.47657-53) Brinton Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day of November 1953, incorporating: Madeline Ferguson, Marie Poulos, secretaries, spinsters of the full age of majority, Edward I.Auerback, barrister and solicitor, of Montreal, Lawrence Marks, barrister and solicitor, of Westmount, all of judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with real estate and immoveable property, under the name of \"Brinton Realty Corp.\", with a capital stock of 820,000, divided into 100 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company to be at the town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of November 1953.C.-E.CANTIN.36154-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.45559-53) Canadian Ruler, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-ninth day of October 1953, incorporating: Marcel Pigeon, advocate, Edmée Fortin, secretary, spinster, Lionel Lcfebvre, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in rulers, yardsticks, gauges, golf tees, boxes of all kinds, glass, cloth, celluloid, all kinds of wooden goods, advertising novelties, pencils, pens, school and office supplies of all kinds, under the name of \"Canadian Ruler, Limited\", with a capital stock of $40,000 divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the Company to be at the Town of Bedford, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of October 1953.L.DÊSLLETS.36154-o Deputy Attorney General. 3608 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 décembre 1968, Tome 85, N° AS (P.G.47579-53) Capitol Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du-trente et unième jour «l'octobre 1953, constituant en corporation: Jack Lionel Switzer, Solomon (Sam) I.Belzberg, tous deux ingénieurs, de la cité de Montréal, Max Coblentz.avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, exercer le commerce et le négoce de marchandises, objets effets faits en entiers, ou en partie de plastique, textiles, tissus, caoutchouc, cuir, papier, verre, celluloide.substances chimiques, teinture, ciment, peinture, huile, acides, bois et métaux, sous le nom de \"Capitol Industries Ltd.\", avec un capital de §50,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 400 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trente et unième jour d\"octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.(P.G.46831-63) Cascade Building Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément, à l'article 2, chapitre 27(5, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-huit octobre 1953, constituant en corporation: Robert Bourassa, commerçant, Winifred Blair, ménagère, épouse de Robert Bourassa, Rose Morin, secrétaire, célibataire, tous de Shawinigan Falls, district judiciaire des Trois-Riviè.res, pour les objets suivants: Agir comme constructeurs et.faire affaires dans les matériaux de construction, sous le nom de \"Cascade Building Company\", avec un capital de §300,'000, divisé en 1,500 actions communes de §100 chacune et en 1,500 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawwini-gan-Falls, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.(P.G.41119-53) Central Loan and Finance Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, SR.Q., 1931, des lettres patentes en date du quatrième jour de novembre 1953, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, de West-mount, Joseph Roy Hoffman, avocat.Oscar, Respitz, étudiant en droit, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de prêts, de finance et de placements, sous le nom de \"Central Loan and Finance Company\", avec un capital de §225,000, divisé en 250 actions ordi- (A.G.47579-53) Capitol Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richclière, in conformity with section 2.chapter 276, R.S.Q., 1941.bearing date the thirty-first day of October 1953, incorporating: Jack Lionel Switzer, Solomon (Sam) I.Bel/berg, both Engineers, of the City of Montreal, Max Coblentz.advocate, of the city of Outremont, all of judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with goods, wares and merchandise made in whole or in part of plastic, textiles, fabrics, rubber, leather, paper, glass, celluloid, chemicals, dye, cement, paint, oil, acids, wood and metals, under the name of \"Capitol Industries Ltd.\", with a capital stock of §50,000 divided into 100 common shares of §100 each and 400 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company to be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first dav of October 1953.L.DÉSILETS, 36154-0 Deputy Attorney General.(A.G.46831-53) Cascade Building Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-eighth day of October 1953, incorporating: Robert Bourassa, merchant, Winifred Blair, housewife, wife of Robert Bourassa, Rose Morin, secretary, spinster, all of Shawinignn Falls, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To operate as builders and deal in building materials, under the name of \"Cascade Building Company\", with a capital stock of §300,000, divided into 1,500 common shares of §100 each and 1,500 preferred shares of §100 each.The head office of the company will be at Shawinigan Falls, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-eighth day of October 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.41119-53) Central Loan and Finance Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2\u201e chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fourth day of November 1953, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, advocate, Oscar Respitz, law student, both of Montreal, all of judicial district of Montreal, for the following-purposes: To carry on the general business of a loan, finance and investment company, under the name of \"Central Loan and Finance Company\", with a capital stock of $225,000, divided into 250 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 5th, 1953, Vol.85, No.A9 3609 naires de S100 chacune, 1,000 actions privilégiées, classe \"B\" de $100 chacune et 1,000 actions privilégiées, classes \"A\" de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de novembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.(P.G.47432-53) Chambly Investment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du.trentième jour d'octobre 1953, constituant en corporation: Lawrence J.Galetti, Jules Bol-duc, industriels, de Greenfield Park, Marc Saint-Mars, architecte, Jean Bruncau, avocat, de Lon-gucuil, Lucien Archambault.comptable, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et «l'améliorâtions, sous le nom de \"Chambly Investment Ltd\", avec un capital de SI 00,000 divise en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Greenfield Park, district judiciaire de Montréal - Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour d'octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.(P.G.47429-53) Chelsea Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richclièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du trentième jour d'octobre 1953, constituant en corporation: Moses Aaron Schwartz, Harry Feinstein, manufacturiers, Madeleine Clément, fille majeure, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des propriétés immobilières et immeubles de toutes descriptions, sous le nom de \"Chelsea Investment Corporation\", avec un capital de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires de SI 00 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal, Daté du bureau du Procureur général, ce trentième jour d'octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.(P.G.47438-53) CofTce-Matic Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies ce Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patenstes en date du trente octobre 1953, constituant en corporation: Robert Stewart Willis, avocat, de West- common shares of $100 each, 1,000 Class \"B\" preferred shares of $100 each and 1,000 Class \"A\" preferred shares of $100 each.The head office of the company to be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of November 1953.\u2022 L.DÉSILETS, 36154-0 Deputy Attorney General.(A.G.47432-53) Chambly Investment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of October 1953, incorporating: Lawrence J.Galetti, Jules Bolduc, Industrials, of Greenfield Park, Marc Cinq-Mars, Architect, Jean Bruneau, Advocate, of Longueuil, Lucien Archambault, Accountant, of Montreal, all of judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and improvement company, under the name of \"Chambly Investment Ltd\", with a capital stock of $100,000 divided into 500 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company to be at Greenfield Park, judicial dustrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of October 1953.L.DÉSILETS, 36154-0 Deputy Attorney General.(A.G.47429-53) Chelsea Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of October 1953, incorporating: Moses Aaron Schwartz, Harry Feinstein, manufacturers, Madeleine Clement, fille majeure, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveable property and real estate of every description, under the name of \"Chelsea Investment Corporation\", with a cspital stock of $40,000 divided into 100 common shares of S100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company to be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of October 1953.L.DÉSILETS, 36154-0 Deputy Attorney General.(A.G.47438-53) Coflcc-Matic Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by tho Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the thirtieth day of October 1953, incorporating: Robert Stewart Willis, lawyer, of Westmount, John David Hac- 3610 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 décembre 1953, Tome 85, N° J,9 mount, John David Hackett, Charles Terri 11 Manning, avocats, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises faits «le cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et sous-pro-«luits, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et périodiques, objets d'art, produits chimiques et de beauté, produits de la terre, «le la mer et de la forêt, sous le nom «le \"Coffec-Matic Company Limited\", avec un capital de 850,000 divisé en 500 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du l'rolureur général, le trente octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154 L.DÉSILETS.(P.G.46382-53) Construction Dumas & Dumas Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes en date du vingt-septième jour d'octobre 1953, constituant en corporation : Albert Sauvage, avocat, de Ville St-Laurent, Aimé Branchaud, Anatole Coté, comptables, de Montréal, tous «lu district judiciaire de Montréal, pour les obje'ts suivants: Exercer le commerce «le constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Construction Dumas & Dumas Ltée\", avec un capital «le S40.000 divisé en 400 actions «le S100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, ce vingt-septième jour d'octobre 1953.L'Assistant-procureur général.36154 L.DÉSILETS.(P.G.47450-53) Drummond Stainless Steel Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, représenté par M.C.LaRiche-.Hère, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en «late du vingt-neuf octobre 1953, constituant en corporation: Dominique Robitaille, agent, de Drum-mondvillc, district judiciaire «l'Arthabaska, Lorenzo Choquette, agent, Armand Nadeau, c.r., de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'effets et ustensiles «le cuisiive pour la cuisson et autres fins domestiques, sous le nom de \"Drummond Stainless Steel Co.Ltd.\", avec un capital de 850,000, divisé en 150 actions ordinaires de S10Q chacune et en 350 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drum-mondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf octobre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.(P.G.47680-53) Duvan Copper Company Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions «le la Loi des compagnies minières de Québec, il a été kett, Charles Terrill Manning, lawyers, of Montreal, all of judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and rest prtxlucts, un«ler the name of \"( offee-Matic Company Limitc«l\", with a capital stock of $50,000 the Honourable Attorney General of Quebec for the acceptance of the surrender of its Charter.Montreal.November 25th, 1953.MARVIN BERCOVITCH, Vice-President., J.R.BOGANTE, Q.C., 36203-o ' .Attorney for Company. 3658 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 décembre 1958, Tome 86, N° A9 AVIS En vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, \"Jack Liss & Sons (Canada) Ltd.\", donne avis par les présentes qu'elle s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec pour demander la permission d'abandonner sa charte et d'obtenir la cancellation d'ieelle à compter de la date qu'il plaira de fixer.Daté à Montréal, ce 25ième jour de novembre 1953.Le Président, 36169-0 JACK LISS, Twin Mountain Home Avis est donné (pie la compagnie \"Twin Mountain Home\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, demandera au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 27ème jour de novembre 1953.Les Procureurs de Twin Mountain Home, 35170 BRODERICK & McQUILLAN.Compagnies dissoutes (P.G.18337-53) Avis est donné qu'en vertu de la première artie de la Loi des compagnies de Québec, tatuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276 article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Albert Nagley Ltd\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 15 juin 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du premier décembre 1953, «ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-o L.DÉSILETS.(P.G.42525-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Huntingdon Realties Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 juillet 1939.Avis est de plus donné qu'à compter du premier décembre 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-o L.DÉSILETS.(P.G.18082-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité dér crétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act Section 26, Jack Liss & Sons (Canada) Ltd.hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor of the Provincejbf Quebec for the acceptance of the surrender of its charter on and from a date to be fixed by Him.Dated at Montreal, this 25th day of November, 1953.JACK LISS, 36169-0 President.Twin Mountain Home Notice is hereby given that \"Twin Mountain Home,\" a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its bead office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General\" of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions o f the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 27th day of November 1953.BRODERICK & McQUILLAN, 36170-o Attorneys for Twin Mountain Home.Companies Dissolved (A.G.18337-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Albert Nagley Ltd\", incorporated by Letters Patent on June 15, 1945.Notice is also hereby given that from and after December 1st, 1953, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, December 2, 1953.L.DÉSLLETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.42525-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Huntingdon Realties Limited\", incorporated by letters patent July 12, 1939.Notice is also hereby given that from and after the first day of December, 1953, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, December 2, 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.18082-53) Notice is hereby given .that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276; R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"John QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 5th, 1953, Vol.85, No.Â9 3659 charte de la compagnie \"John R.Hoyle, Agent, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 octobre 1932.Avis est de plus donné qu'à compter du premier décembre 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-o L.DÉSILETS.- (P.G.12248-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"La Chaussure B & B Inc.\u2014 B & B Shoe Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 juin 1946.Avis est «le plus donné qu'à compter du premier décembre 1953, ladite compagnie^ été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-p/ocureur général, 36154-o L.DÉSILETS.R.Hoyle Agent, Limited,\" incorporated by letters patent, dated the twenty-fourth day of October 1932.Notice is also hereby given that from anil after the first day of December 1953, the said company has been dissolved.Datc«l at the office of the Attorney General, this second dav of December 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.12248-52) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Chaussure B & B Inc.\u2014B & B Shoe Inc.\", incorporated by letters patent dated the fourteenth day of June 1946.Notice is also hereby given that from and after the first day of December 1953, the sai«l company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(P.G.6690-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'ahandcn de la charte de la compagnie \"Nerem Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 juillet 1950.Avis est de plus donné qu'à cempter du premier décembre 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.(P.G.19983-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Ici, il a plu au Procureur général d'accepter- l'abandon de la charte de la et mpagnic \"Service Contracting Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 7 juillet 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du premier décembre 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-o L.DÉSILETS.(P.G.42347-53) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi.des compagnies «le Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Valley Flax Products Ltd\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 octobre 1944.(A.G.6690-52) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Ncrom Limited\", incorporated by letters patent on July 11, 1950.Notice is also hereby given that from and after December first 1953.the said company has been disse Ived.Dated at the office of the Attorney General, December 2, 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.19983-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter «:f the company \"Service 'Contracting Company Limited\", incorporated by letters patent cn July 7, 1944.Notice is also hereby given that from and after December 1st, 1953, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General.December 2.1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.(A.G.42347-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q.-, 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surremler of the charter of the company \"Valley Flax Products Ltd\", incorporated by letters patent dated October 11, 1944. 3660 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 décembre 1958, Tome 85, N° 19 Avis est de plus donné qu'à compter du premier décembre 1953, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 décembre 1953.L'Assistant-procureur général, 36154-0 L.DÉSILETS.Notice is also hereby given that from and after the first day of December 1953, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December 1953.L.DÉSILETS, 36154 Deputy Attorney General.Curatelle publique Canada \u2014 Province de Quebec District de Québec Succession vacante de Leonard Hudson, con cierge, en son vivant de 151, rue Arago, Québec.If [Le soussigné donne avis «pie cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 13 novembre 1952 par un juge «le la cour supérieure siégeant à Québec dans le district de Québec que, sous l'autorité «le la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement «le toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC, 187} rue Sainte-Catherine (Ouest), 36171-o Montréal 18.Public Curatorship Cana«la \u2014 Province of Quebec District of Quebec Vacant estate of Léonard Hudson, janitor, in his lifetime of 151, Arago Street, Quebec.The undersignc«l gives notice that this estate was declare*! vacant by virtue of a judgment rendered November 13.1953, by a Judge of the Superior Court sitting at Quebec, in the district of Quebec, that, under the authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI, c.62) he is curator ex officio of this estate and that he will receive, at the ad«lrass given below, payment of any debt owing to the estate and the proof of anv claim against it.PUBLIC CURATOR, 187, Saint-Catherine Street (West).36171 Montreal 18.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 16-51 A Extrait des procès-verbaux des s
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.