Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 6 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1954-03-06, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 86, N° 10 777 Vol.86, No.10 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act rejecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (PUBUÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBU SHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 6 mars* 1954 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, March 6th, 1954 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 778 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1951, Tome 86, N° 10 délai pour la réception des avis, documents ou receiving notices, documents or advertising annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi copy, for publication, expires at noon on Thurs-à condition que l'un des trois derniers jours de day, provided that none of the last three days of la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce (1er- the week be a holiday.In the latter case, the nier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, ultimate delay expires at noon on Wednesday.Les avis, documents ou annonces reçus en retard Notices, documents or advertising copy not resont publiés dans une édition subséquente.De ceived on time, will be published in a subsequent plus, l'Imprimeur de la Heine a le droit de retarder edition.Moreover the Queen's Printer is entitled la publication de certains documents, à cause dc to delay the publication of certain documents, leur longueur ou pour des raisons d'ordre admi- due to their length or for reasons of administra-nistratif.tion.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes 8.Any demands for cancellation or any remit-remises d'argent sont soumises aux dispositions tances of money are subject to the provisions of de l'article 7.article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans 9.If a typographical error occurs in the first une première insertion, les intéressés sont priés insertion, the interested parties arc requested to d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la advise the Queen's Printer before the second seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et insertion, so as to avoid, for both parties, onerous d'autre, des frais onéreux de reprise.costs of republishing.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Advertising Rates, Subscriptions, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour First insertion: 15 cents per agate line, for each chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per lignes par page, paur les deux versions).page, for both versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate Subsequent insertions: 5 cents per agate line, pour chaque version.for each?version.La matière tabulaire (listes de noms, de chif- Tabular matter (list of names, figures, etc.) at fres, etc.) est comptée double.double rate.Traduction: 50 cents des 100 mots.Translation: 50 cents per 100 words.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Single copies: 30 cents each.Feuilles volantes: SI la douzaine.Slips: SI.per dozen.Abonnement: S7 par année.Subscriptions: S7.per ear.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices ont la signification suivante: have the following meaning: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'or- The first figure refers to our document number; dre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette the second to that of the edition of the Gazette pour la première insertion; le troisième à celui for the first insertion; the third the number of du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie insertions, and the letter \"o\" signifies that the que la matière n'est ni dc notre composition ni copy was neither our composition nor our trans- de notre traduction.Les avis publiés une seul lation.Notice published but once are followed fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre, only by our document number.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS, RÉDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.Government House.Quebec, June 27th, 1940.36322 \u2014 1-52 36322 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.10063-54) Abitibi Propane Gas Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente janvier 1954.constituant en corporation: Charles-Edouard Massicotte, télégraphiste, Albert Massicotte, commis, Geo.-H.Bouchard, comptable, tous de La Tuque, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de tous produits se rapportant au gaz propane, sous le nom de \"Abitibi Propane Gas Co.Ltd.\", avec un capital total de SI 25,000, divisé en 1,000 actions communes de SI 00 chacune et en 250 actions privilégiées de SI 00 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le trente janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DESKJETS.Letters Patent (A.G.10063-54) Abitibi Propane Gas Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of January 1954, incorporating: Charles Edouard Massicotte, Telegraph Operator, Albert Massicotte.Clerk, Geo.H.Bouchard, Accountant, all of La Tuque, judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in all products ralatcd to propane gas, under the name of \"Abitibi Propane Gas Co.Ltd.\", with a total capital stock of 8125,000, divided into 1,000 common shares of $100 each and 250 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, the thirtieth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1954, Vol.86, No.10 779 (P.G.10032-54) Aetna Investment Corporation Corporation de Placement Aetna Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1954, constituant en corporation: Paul-F.Girard, manufacturier, Henri-Paul Lemay, avocat, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, Henri Girard, ingénieur civil, de Lévis, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les fonctions d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Aetna Investment Corporation\"\u2014\"Corporation de Placement Aetna\", avec un capital total de $100,000, divisé en 20,000 actions communes d'une valeur au pair de SI chacune et en 4,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S20 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quinze janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(P.G.50630-53) Barone Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit janvier 1954, constituant en corporation: Luigi Barone, entrepreneur, Jean-Bcrchmans Bélanger, Paul-Henri Lafleur, comptables, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les ogjets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux et constructeurs et exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Barone Co.Ltd\", avec un capital divisé en 200 actions sans valeur au pair ou nominale et en 90 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10188-54) Bcaudry Maple Products Inc.Les Produits d'Érable Beaudry Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq janvier 1954, constituant en corporation: F.-Ludger Beaudry, industriel, Marie-Louise Fortier-Beaudry, ménagère, épouse séparée de biens dudit F.-Ludger Beaudry, Gaétan Beaudry, comptable, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de tous produits de l'érable, sous le nom de \"Beaudry Maple Products Inc., \u2014 Les Produits d'Érable Beaudry Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair ou nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.(A.G.10032-54) Aetna Investment Corporation Corporation de Placement Aetna Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January 1954, incorporating: Paul F.Girard, manufacturer, Henri Paul Lemay, Advocate, both of the city and judicial district of Montreal, Henri Girard, civil Engineer, of Levis, judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as an investment company, under the name of \"Aetna Investment Corporation\" \u2014\"Corporation de Placement Aetna\", with a total capital stock of S 100,000.divided into 20,000 common shares of a par value of $1 each and 4,000 preferred shares of a par value of §20 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fifteenth day of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.50630-53) Barone Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act Letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of January 1954, incorporating: Luigi Barone, contractor, Jean-Berchmans Bélanger, Paul-Henri Lafieur, accountants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders and to deal in building materials, under the name of \"Barone Co.Ltd\", with a capital divided into 200 shares without nominal or or par value and into 90 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-eighth day of January of 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10188-54) Beaudry Maple Products Inc.Les Produits d'Érable Beaudry Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January 1954, incorporating: F.Ludger Beaudry, industrial, Marie-Louise Fortier-Beaudry, housewife, wife separate as to property of said F.Ludger Beaudry, Gaétan Beaudry, accountant, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To fabricate and deal in all maple products, under the name of \"Beaudry Maple Products \u2014 Les Produits d'Érable Beaudry Inc.\" with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a.nominal or par value of $100 each.The head office of the Company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis. 780 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1964, Tome 86, N° 10 Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq janvier 1954.L'Assist ant-procureu r général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10177-54) Bcnuuionl Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de la province de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois janvier 1954, constituant en corporation: Jean Mouette, avocat, dc Longucuil, Lucille Beaupré, Rita Angers, toutes deux sténographes, filles majeures, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Beaumont Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability)\", avec un capital total de S4,000,000, divisé en 4,000,000 actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10214-54) Bilodcau & Doré Limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept janvier 1954, constituant en corporation: David Bilodcau, André Bilodeau, industriels, Gabriellc Gamcau Bilodeau, ménagère, épouse contractucllemcnt séparée de biens dudit David Bilodcau et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du bois et de toutes choses dans lesquelles entre du bois, sous le nom de \"Bilodeau & Doré Limitée\", avec un capital total de S50.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune et en 1,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS, (P.G.10132-54) Bungalow Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux janvier 1954, constituant en corporation: Manuel Sachs, comptable, Lenore Glovcn, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, Max S.Kaufman, avocat, de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Dated at the office of the Attorney General the twenty-fifth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10177-54) Beaumont Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Mining Companies Act, Letters Patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of January 1954, incorporating: Jean Monette, advocate, of Longueuil, Lucille Beaupré, Rita Angers, both stenographers, spinsters, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Beaumont Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability)\", with a total capital stock of $4,000,-000, divided into 4,000,000 shares of $1 each.The shareholders shall incur no personal responsibility in excess to the amount of the price paid or to be paid to the Company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10214-54) Bilodeau & Doré Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January 1954, incorporating: David Bilodeau, André Bilodcau, industrialists, Gabriel le Garncau Bilodeau, housewife, wife contractually separated as to property of the said David Bilodeau and duly authorized by the latter for the purposes thereof, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of and deal in lumber and all products in the manufacture of which wood is used, under the name of \"Bilodeau & Doré Limitée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 400 common shares of $100 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh day of January 1954.L.DESILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10132-54) Bungalow Construction Ltd.Notice is hereby given that under the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of January 1954, incorporating: Manuel Sachs, accountant, Lenore Gloven, secretary, fille majeure, both of Montreal, Max S.Kaufman, lawyer, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1964, Vol.86, No.10 781 Faire affaires comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Bungalow Construction Ltd.\", avec un capital divisé en 2,000 actions sans valeur au pair ou nominale - et en 1,900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera A Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux janvier 1954.( L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10080-54) Canada Dactylographe Inc.Canada Typewriter Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettrés patentes, en date du vingt-cinq janvier 1954, constituant en corporation: Rosario T.Armand, commerçant, dc Westmount, Aima T.Armand, secrétaire,- de Montréal, René T.Armand, commerçant, de Notre-Damc-de-GrAce, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de machines, meubles et accessoires de bureau et tout autre équipement ou mobilier quelconque, sous le nom de \"Canada Dactylographe Inc.\", \u2014 \"Canada Typewriter Inc.\" avec un capital total de $100,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair ou nominale de $100 chacune et en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair ou nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera A Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DESILETS.To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Bungalow Construction Ltd.\", with a capital divided into 2,000 shares without nominal or par value and into 1,900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-second day of January 1954.L.DESILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10080-54) Canada Dactylographe Inc.Canada Typewriter Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January 1954, incorporating: Rosario T.Armand, Merchant, of Westmount, Alma T.Armand, Secretary* of Montréal, René T.Armand, Merchant, of Notre Dame de Grâce, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in office machinery, furniture and supplies, and all other equipment or furniture whatsoever, under the name of \"Canada Dactylographe Inc.\"\u2014\"Canada Typewriter Inc.\", with a total capital stock of S100.000, divided into 200 common shares of a nominal and par value of SI 00 each and 800 preferred shares of a nominal and par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twentv-fifth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(P.G.10252-54) Canadian Neutral Sulphite Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf janvier 1954, constituant en corporation: Chas-Ed.Boivin, industriel, Paul Simard, gérant de banque, tous deux de St-Jérôme-de-Metabctchouan, district judiciaire dc Roberval, Margaret P.Lemieux, femme d'affaires, veuve, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de bois, de papier, de pidpe, de leurs composés, ingrédients ou dérivés, sous le nom de \"Canadian Neutral Sulphite Corporation\", avec un capital total de $2,000,000, divisé en 2,000,000 d'actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera A 311, avçnue Laurier, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(P.G.10109-54) Château Huntingdon Incorporée Château Huntingdon Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date (A.G.10252-54) Canadian Neutral Sulphite Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of January 1954, to incorporating: Chs.Ed.Boivin, industrialist, Paul Simard, bank manager, both of St.Jérôme-Metabet-chouan, judicial district of Roberval, Margaret P.Lemieux, business woman, widow, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in wood, paper, pulp and the compounds, ingredients and derivatives thereof, under the name of \"Canadian Neutral Sulphite Corporation\", with a total capital stock of S2,000,000, divided into 2,000,000 shares of SI each.The head office of the company will be at 311 Laurier Avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General the twenty-ninth day of January 1954.C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10109-54) Château Huntingdon Incorporée Château Huntingdon Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty- 782 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1951, Tome 86, N° 10 du vingt et un janvier 1954, constituant en corporation: Norbert David Barnabe, marchand d'automobiles, de Ville Mont-Royal, Annette Daignault, de Montréal, Paula Deslauriers, de Saint-Lambert, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôtelier, sous le nom de \"Château Huntingdon Incorporée \u2014 Château Huntingdon Incorporated\", avec un capital total de 8500,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et en 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Huntingdon, district judiciaire dc Bcauharnois.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.7738-53) Club No.77 Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt janvier 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Windsor Holloway, Arthur Tarry, contremaîtres, Fernand Bouchard, gérant, tous de Waterloo, district judiciaire dc Bedford, pour les objets suivants: Former une association à caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, mais sans but lucratif, sous le nom de \"Club No.77\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 825,000.Le siège social de la compagnie sera à Waterloo, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le vingt janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.(P.G.10039-54) Delta Furs and Skin Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1954, constituant'en corporation: Alex Basch, Lily Ebenspanger Basch, épouse séparée de biens dud it Alex Basch et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, Regina Ebenspanger, tous marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de fourrures, sous le nom de \"Delta Furs and Skin Company\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le neuf janvier 1954.fL'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(P.G.10023-54) Desnoyers & Beauchemin Ltée first day of January 1954, incorporating: Norbert David Barnabe, automobile dealer, of the town of Mount-Royal, Annette Daignault, of Montreal, Paida Deslaruricrs, of Saint-Laubert, the two latter secretaries, filles majeures, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hotel-keeper, under the name of \"Château Huntingdon Incorporée \u2014 Château Huntingdon Incorporated\", with a total capital stock of $500,000 divided into 2,500 common shares of a par value of $100 each and into 2,500 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Huntingdon, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.7738-53) .Club No.77 Notice is hereby given that under Part ni of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of January 1954, to incorporate a corporation without share capital: Windsor Hollo-way, Arthur Tarry, foremen, Fernand Bouchard, manager, all of Waterloo, judicial district of Bedford, for the following purposes:.To form an association of a national, patriotic, religious, philanthropic, charitable, scientific, artistic, social, professional or sporting nature, but not for pecuniary gain, under the name of \"Club No.77\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation mav hold is to be limited, is $25,000.The head office *of the Company will be at Waterloo, judicial district of Bedford.Dated\" at the office of the Attorney General, the twentieth day of January 1954.C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10039-54) Delta Furs and Skin Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January 1954, incorporating: Alex Basch, Lily Ebenspanger Basch, wife separate as to property of the said Alex Basch and duly authorized by him for the purposes thereof, Regina Ebenspanger, all merchants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, under the name of \"Delta Furs and Skin Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the ninth day of January 1954.C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10023-54) Desnoyers & Beauchemin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1954, Vol.86, No.10 783 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1954, constituant en corporation: Léandre Prévost, Guy Guérin, avocats.Thérèse Brouille!te, secrétaire, tous trois de Montréal, Guy Robert, avocat, d'Outremont, René Labelle, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Opérer un commerce de marchandises sèches, sous le nom de \"Desnoyers & Bcauchcmin Ltée\", avec un capital total dc 8100,000, divisé en 750 actions ( liasse A de 8100 chacune et en 250 actions Classe lî de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Farnham, district judiciaire dc Bedford.Daté du bureau du Procureur général le quatorze janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.(P.G.10090-54) Eastern Canada Forest Products Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation: Maurice Tcssier, avocat, Béatrice d'Anjou, Hélène Côté, toutes deux secrétaires, tous de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce du bois, sous le nom de \"Eastern Canada Forest.Products Inc.\", avec un capital total de 875,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc 825 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 825 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski-Est, district judiciaire dc Rimouski.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 30738-o C.-E.CANTIN.(P.G.10157-54) Elite Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept janvier 1954, constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de West-mount, Sydney Phillips, avocat, Rose-Marie Bourgoing, sténographe, fille majeure, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Elite Investment Corporation\", avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale et en 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-o L.DÉSILETS.(P.G.10108-54) Epicerie du Sous-Sol Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January 1954, incorporating: Léandre Prévost, Guy Guérin, advocates, Thérèse Brouil-lette, secretary, all three of Montreal, Guy Robert, advocate, of Outremont, René Labelle, advocate, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a dry goods business, under the name of \"Desnoyers & Beauchemin Ltée\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 750 Class A shares of S100 each and 250 Class B shares of 8100 each.The head office of the company will be at Farnham, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, the fourteenth day of January 1954.C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10090-54) Eastern Canada Forest Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954, incorporating: Maurice Tcssier, Advocate, Beatrice d'Anjou, Hélène Côté, both Secretaries, all of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To manufacture and carry on a lumber business, under the name of \"Eastern Canada Forest Products Inc.\", with a total capital stock of 875,000, divided into 2,000 common shares of a par value of 825 each and 1,000 preferred shares of a par value of 825 each.The head office of the company will be at Rimouski-East, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-sixth dav of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10157-54) Elite Investment Corporation Notice is hereby given that under the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January 1954, incorporating: John J.Wasserman, lawyer, of Westmount, Sydney Philips, lawyer, Rose-Marie Bourgoing, stenographer, fille majeure, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding and investment company, under the name of \"Elite Investment.Corporation\", with a capital divided into 1,000 common shares without nominal or par value and into 1,500 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh dav of January 1954.L.DÉSILETS, 3673S Deputy Attorney General.(A.G.10108-54) Epicerie du Sous-Sol Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 784 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1954, Tome 86, N° 10 vince de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq janvier 1954, constituant en corporation: Joseph-Eugène Tremblay, marchand, Marie-France Savard-Tremblay, ménagère, épouse contractuellcment séparée de biens dudit Joseph-Eugène Tremblay, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, Marcel Girard, chef de département, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Agir comme marchand d'épicerie, dc ferronnerie, de boucherie et dc marchandises sèches, sous le nom de \"Épicerie du Sous-Sol Ltée\", avec un capital total dc 820,000, divisé en 200 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 535, avenue Montcalm, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10161-54) F.Courtemanche Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation: Roland G.Lefrançois, Chs.-Ed.Bertrand, avocats, Jeannine Roy, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'ameublements, d'accessoires électriques et de tous articles d'utilité domestique, sous le nom de \"F.Courtemanche Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 400 actions communes de $100 chacune et en 600 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6729, rue Saint-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-o L.DÉSILETS.(P.G.10160-54) George Automobile Limitée ¦ George Automobile Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation: George Forget, Nessim Chitayat, commerçants, Claude Picard, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles et d'appareils de télévision et des parties et accessoires se rapportant audit commerce, sous le nom de \"George Automobile Limitée \u2014 George Automobile Limited\", avec un capital total de 850,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8777, rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSDLETS.Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January 1954, incorporating: Joseph-Eugène Tremblay, merchant, Marie-France Savard-Tremblay, housewife, wife contractually separated as to property of said Joseph-Eugène Tremblay, and duly authorized by him for the purposes thereof, Marcel Girard, Departmental Manager, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To act as merchant dealing in groceries, hardware, butchery and dry goods, under the name of \"Épicerie du Sous-Sol Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 535 Montcalm Avenue, judicial district of Chicoutimi.Dated at* the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General (A.G.10161-54) F.Courtemanche Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954, incorporating: Roland G.Lefrançois, Chs.Ed.Bertrand, advocates, Jeannine Roy, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in furniture, electrical appliances and all articles of a domestic utility, under the name of \"F.Courtemanche Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 400 common shares of $100 each and 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 6729 St.Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-sixth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10160-54) George Automobile Limitée George Automobile Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954, incorporating: George Forget, Nessim Chitayat, merchants, Claude Picard, advocate, all of the city and judicia district of Montreal, for the following purposesl To deal in automobiles and television apparatus, and parts and accessories connected therewith, under the name of \"George Automobile Limitée \u2014 George Automobile Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 250 common shares of $100 each and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at 8777 Lajeunesse Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the twenty-sixth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1954, Vol.86, No.10 785 (P.G.10079-54) Gerard Pageau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux janvier 1954, constituant en corporation: Yves Pratte, avocat, dc Sillery, Charles Tremblay, avocat, André-Miville-Dechéne, étudiant en droit, ces deux derniers de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de la chaussure et de tous articles ou objets dans lesquels entrent du cuir et ses sous-produits, sous le nom de \"Gérard Pageau Limitée\", avec un capital total dc 8125,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 8,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Emile, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.(P.G.10141-54) Gérard Sauvageau Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit janvier 1954, constituant en corporation: Gérard Sauvageau, constructeur, Jeannette Machabée, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Gérard Sauvageau, tous deux de Ville Saint-Michel, Stanislas Machabée, ingénieur, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneur en construction, sous le nom de \"Gérard Sauvageau Construction Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7356, 2ème avenue, Ville Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSDLETS.(P.G.10189-54) G.-S.-G.Hosiery Mills Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du, vingt-cinq janvier 1954, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur D.Ruby, Lewis J.Manolson, ces deux derniers comptables agréés, Mildred Brown, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements, sous le nom de \"G.-S.-G.Hosiery Mills Limited\", avec un capital total de $100,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 367.8-o C.-E.CANTIN.(A.G.10079-54) Gérard Pageau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of January 1954 incorporating: Yves Pratte, advocate, of Sillery, Charles Tremblay, advocate, André Miville-Dechêne, student at law, the two latter of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in footwear and all articles or objects in the manufacture of which leather and its by-products arc used, under the name of \"Gérard Pageau Limitée\", with a total capital stock of $125,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each and 8,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the Company will be at Saint-Emile, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General the twenty-second day of January 1954.C.-E.CANTIN.36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10141-54) Gérard Sauvageau Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Piovince of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of January 1954, incorporating: Gérard Sauvageau, builder, Jeannette Machabée, housekeeper, wife contractually separate as to property of said Gérard Sauvageau, both of the town of Saint-Michel, Stanislas Machabée, engineer, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as building contractor under the name of \"Gérard Sauvageau Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of a par value of $100 and 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 7356, 2nd Avenue, town of St.Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-eighth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10189-54) G.-S.-G.Hosiery Mills Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January 1954, incorporating: Milton Lower Klein, advocate, Arthur D.Ruby, Lewis J.Manolson, the two latter, Chartered Accountants, Mildred Brown, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"G.-S.-G.Hosiery Mills Limited\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at St.John, judicial district of Roerville.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of January 1954.C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1954, Tome 86, N° 10 (P.G.10202-54) Hôtel New Wellington Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept janvier 1954, constituant en corporation: Eddy Blouin, Roger Bourgault, hôteliers, Madame Marcelle Bourgault, épouse séparée dc biens dudit Roger Bourgault, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Sherbrooke, district judiciaire dc Saint-François, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Hôtel New Wellington Limitée\", avec un capital total dc 8275,000, divisé en 2,750 actions de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 68, rue Wellington Sud, Sherbrooke, district judi-ciare de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.51973-53) Hutchins Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze janvier 1954, constituant en corporation: John Henry Ernest Colby, avocat, Galen Lee Prime, gérant, Elizabeth Catherine Fraser, opératrice, Lillias Watson Noble, Aubra Pollitzcr secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom dc \"Hutchins Investment Corporation\", avec un capital divisé en 16.000 actions ordinaires sans valeur au pair nominale et en 160,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le douze janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.(P.G.51942-53) Joseph Y.Nadler & Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf janvier 1954, constituant en corporation : Alan B.Gold, avocat, Morris Weiner, étudiant en droit, tous deux de Montréal, Murray Lapin, avocat, de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents d'assurance, sous le nom de \"Joseph Y.Nadler & Co.Inc.\", avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale et en 350 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(A.G.10202-54) Hôtel New Wellington Limitée Notice is hereby given that under the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January 1954, incorporating: Eddy Blouin, Roger Bourgault, hotel-keepers, Madame Marcelle Bourgault, wife separate as to property of said Roger Bourgault and duly authorized by the latter for the purposes hereof all of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers and restaurant-keepers, under the name of \"Hôtel New Wellington Limitée\", with a total capital stock of 8275,000 divided into 2,750 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 68 Wellington South St., Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh dav of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.51973-53) Hutchins Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January 1954, incorporating: John Henry Ernest Colby, Advocate, Galen Lee Prime, Manager, Elizabeth Catherine Fraser, Operator, Lillias Watson Noble, Aubra Pollitzcr, Secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of .\"Hutchins Investment Corporation\", with a capital stock divided into 16,000 common shares without nominal or par value and 160,000 preferred shares of a par value of 85 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the twelfth dav of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.51942-53) Joseph Y.Nadler & Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of January 1954, incorporating: Alan B.Gold, advocate, Morris Weiner, student at Law both of Montreal, Murray Lapin, advocate of Hampstead, all of the judicial district of Montréal for the following purposes : To carry on the business of brokers and insurance agents, under the name of \"Joseph Y.Nadler & Co.Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without nominal or par value and 350 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the nineteenth day of January 1954.C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 195/,, Vol.86, No.10 787 (P.G.10155-54) King Copper Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des com- Ïagnies minières dc Québec, il a été accordé par le .ieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation: Lovell C.Carroll, c.r., avocat, de Ville Mont-Royal, Jean-Paul Cardinal, Marcel Lajeunesse, Jacques P.Danscrcau, avocats, Anna Mikula, secrétaire, fille majeure, ces quatre derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom dc \"King Copper Mining Corporation (No Personal Liability)\", avec un capital total de $3,500,000, divisé en 3,500,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu dc payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10182-54) Laboratoire Cartier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois janvier 1954, constituant en corporation: Paul-Henri Soucy, pharmacien, Léonie Marceau Soucy, ménagère, épouse séparée de biens dudit Paul-Henri Soucy et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, Odilon Marceau, marchand, Augustin Letarte, comptable, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce en gros de tous produits pharmaceutiques et de tous produits et articles généralement vendus dans les Eharmacies, sous le nom dc \"Laboratoire Cartier ic\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 160, rue St-Cyrille, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.(P.G.10115-54) La Cie des Distributeurs Economiques Ltée Economie Jobbers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorcé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit janvier 1954, constituant en corporation: Edmund Gordon, avocat et procureur, Madeline Ferguson, Marie Poulos, secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme distributeurs de marchandises de toutes sortes, sous le nom de \"La Cie des Distributeurs Economiques Ltée \u2014 Economie (A.G.10155-54) King Copper Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954, incorporating: Lovell C.Carroll, Q.C., advocate, of the town of Mount Royal, Jean Paul Cardinal, Marcel Lajeunesse, Jacques P.Dansereau, advocates, Anna Mikula, secretary, spinster, the last four from Montreal, .all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"King Copper Mining Corporation (No Personal Liability)\", with a total capital stock of S3.500.000, divided into 3,500,000 shares of a par value of SI each.The shareholders shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-sixth clay of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10182-54) Laboratoire Cartier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of January 1954, incorporating: Paul Henri Soucy.Druggist, Léonie Marceau Soucy, housewife, wife separate as to property of said Paul Henri Soucy and duly authorized by the latter for the purposes herein set forth, Ôdilon Marceau, merchant Augustin Letarte accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and carry on a wholesale business of all pharmaceutical products, and of all products and articles generally sold in pharmacies, under the name of \"Laboratoire Cartier Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the Company will be at 160 St.Cyrille street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third day of January 1954.* C.-E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10115-54) La Cie des Distributeurs Economiques Ltée Economie Jobbers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of January 1954, incorporating: Edmund Gordon, advocate and attorney Madeline Ferguson, Marie Poulos, secretaries, fille majeures making use of their rights, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as distributors of merchandise of every nature and kind, under the name of \"La Cie des Distributeurs Economiques 788 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1954, Tome 86, N° 10 Jobbers Ltd.\", avec un capital total dc $10,000, divisé en 20 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 80 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.Ltée \u2014 Economie Jobbers Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 20 common shares of a par value of $100 each and 80 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the twenty-eighth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(P.G.10223-54) (A.G.10223-54) La Compagnie de Construction Mannibec La Compagnie de Construction Mannibec Limitée Limitée The Mannibec Construction Company The Mannibec Construction Company Limited Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec,, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept janvier 1954, constituant en corporation: J.-Alfred Drouin, gérant de bureau, dc Sillery, Gilbcrte Duchène, téléphoniste, de Québec, Thérèse Paquet, sténo-dactylo, de Char-lesbourg-Ouest, tous du district judiciaire dc Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux et exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom dc \"La Compagnie de Construction Mannibec Limitée \u2014 The Mannibec Construction Company Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du -bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-o L.DÉSILETS.(P.G.10118-54) L'Auberge du Boulevard Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation : Aimas Desbiens, hôtelier, Êmilienne Desbiens, secrétaire, Solange Tremblay Claveau, ménagère, épouse séparée de biens de Marcel Claveau, notaire, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtelier, sous le nom de \"L'Auberge du Boulevard Ltée\", avec un capital total de $30,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 100 actions-privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Later-rière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January 1954, incorporating: J.Alfred Drouin, office manager, of Sillery, Gilbcrte Duchène, telephone operator, of Quebec, Thérèse Paquet, Steno-typist, of Charlesbourg West, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as general contractors and deal in building materials, under the name of \"La Compagnie de Construction Mannibec Limitée \u2014 The Mannibec Construction Company Limited\", with a total capital stock of $50,000 divided into 500 shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(P.G.10146-54) Lauzon Drive Yourself Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première \u2022 partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation: Léonard Lauzon, administrateur, Max Slapack, avocat Sylvia Teitlebaum, fille ma- (A.G.10118-54) L'Auberge du Boulevard Ltée Notice is hereby given that under the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954, incorporating: Almas Desbiens, hotel-keeper, Êmilienne Desbiens, secretary, Solange Tremblay Claveau, housewife, wife separate as to property of Marcel Claveau, notary, and duly authorized by the latter for the purposes hereof all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on business as hotel-keeper, under the name of \"L'Auberge du Boulevard Ltée\", with a total capital stock of $30,000 divided into 200 \u2022common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Laterrière, judicial district of Chitoutimi.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-sixth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10146-54) Lauzon Drive Yourself Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954, incorporating: Léonard Lauzon, administrator, Max Slapack, advocate, Sylvia Teitlebaum, fille majeure, all QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1954, Vol.86, No.10 789 jcure, .tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de location d'automobiles, sous le nom de \"Lauzon Drive Yourself Inc.\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 3b738-o L.DÉSILETS.(P.G.51971-53) Les Amusements Nap.Côté, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1954, constituant en corporation: Jean Dolbec, comptable, Paul-E.Bernier, avocat, tous deux de Québec, Paul Chartrain, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'articles de sport, de vêtements et de quincaillerie, sous le nom de \"Les Amusements Nap.Coté, Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10_chacune et en| 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 16, rue St-Joseph, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le cinq janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.(P.G.50692-53) Les Fabricants Mobilier Moderne Compagnie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1953, constituant en corporation: Gérard Laganière, Raphaël Beau-dette, avocats, Sylvette Sylvestre, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles et d'ameublements, sous le nom de \"LesFabri-cants Mobilier Moderne Compagnie Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.\u2022 Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 ,C.E.CANTIN, (P.G.10304-54) Les Loisirs Notre-Dame de Sorel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq février 1954, constituant en corporation sans capital-actions: Fernand Lefebvre, entrepreneur-électricien, Oscar Salois, commis, Jcan-Cournoyer, mécanicien, tous de Sorel, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in automobiles for hire, under the name of \"Lauzon Drive Yourself Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-sixth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.51971-53) Les Amusements Nap.Côté, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January 1954, incorporating: Jean Dolbec, accountant, Paul E.Bernier, advocate, both of Quebec, Paul Chartrain, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in sporting articles, wearing apparel and hardware, under the name of \"Les Amusements Nap.Coté, Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,5000 common shares of a par value of $10 each and into 500 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at 16 St.Joseph Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General the fifth day of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.50692-53) Les Fabricants Mobilier Moderne Compagnie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters Patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December 1953, incorporating: Gérard Laganière, Raphaël Beaudette, advocates, Sylvette Sylvestre, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of and deal in furniture and furniture suites, under the name of \"Les Fabricants Mobilier Moderne Compagnie Ltée\", with a total capital stock of S100,000, divided into 500 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the thirty-first day of December 1953.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10304-54) Les Loisirs Notre-Dame de Sorel Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of February 1954, to incorporate as a corporation without share capital: Fernand Lefebvre, electrical contractor, Oscar Salois, Clerk Jean Cour-noyer, mechanic, all of Sorel, judicial district of Richelieu, for the following purposes: 790 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1954, Tome 86, N° 10 Organiser des loisirs dans la paroisse de Notre-Dame de Sorel, sous le nom dc \"Les Loisirs Notre-Dame de Sorel Inc.\", Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de S2Ô,000.Le siège social dc la corporation sera à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1954.L'Assistant-procureur général, 3G738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10088-54) Les Marchandises Sèches de Sherbrooke Liée (Sherbrooke Dry Goods Ltd.) Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un janvier 1954, constituant en corporation: Salomon Ayoub, Gérard Bérard, tous deux commerçants, Juliette Gaudreau Ayoub, ménagère, épouse séparée de biens dudit Salomon Ayoub et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de mercerie et tout ce qui s'y rapporte, sous le nom de \"Les Marchandises Sèches de Sherbrooke Ltée (Sherbrooke Dry Goods Ltd.)\", avec un capital de 825,000, divisé en 2,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.50718-53) Lucerne Finance Corporation Limited La Compagnie de Finance Lucerne Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente janvier 1954, constituant en corporation: Fernand Picard, Roger Picard, tous deux gérants d'Outremont, Fernand Gendron, gérant de service de garage, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce de prêteurs d'argent, sous le nom de \"Lucerne Finance Corporation Limited \u2014 La Compagnie de Finance Lucerne Limitée\", avec un capital total de 8250,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3547, avenue du Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10175-54) MacGregor House Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date To organize recreational activities in the Parish of Notre-Dame de Sorel, under the name of \"Les Loisirs Notre-Dame de Sorel Inc.\" The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 825,000.The head office of the Company will be at Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, the fifth day of February 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10088-54) Les Marchandises Sèches de Sherbrooke Ltée (Sherbrooke Dry Goods Ltd.) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of January, incorporating: Salomon Ayoub, Gérard Bérard, both merchants, Juliette Gaudreau Ayoub, housewife, wife separate as to property of the said Salomon Ayoub and duly authorized by the latter for the purposes thereof, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods and small wares, and anything connected therewith under the name of \"Les Marchandises Sèches de Sherbrooke Ltée (Sherbrooke Dry Goods Ltd)\", with a total capital stock of 825,000, divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the Company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General the twenty-first day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.50718-53) Lucerne Finance Corporation Limited La Compagnie de Finance Lucerne Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of January 1954, incorporating: Fernand Picard, Roger Picard, both managers, of Outre-mont, Fernand Gendron, service manager, of Montreal, all of the judicial district of Mont-treal, for the following purposes: To carry on the business of money lenders, under the name of \"Lucerne Finance Corporation Limited \u2014 La Compagnie de Finance Lucerne Limitée\", with a total capital stock of 8250,000, divided into 2,500 common shares of 8100 each.The head office of the Company will be at 3547 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the thirtieth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10175-54) MacGregor House Inc.Notice is hereby given that under the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by 'the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, bearing date the twenty-eighth day of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1964, Vol.86, No.10 791 du vingt-huit janvier 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, Abraham M.Klein, avocats, Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille et de placements, sous le nom de \"MacGregor House Inc.\", avec un capital divisé en 2,000ac-tions ordinaires sans valeur au pair et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.10110-54) Montarville Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq janvier 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, avocats.Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Montarville Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Lambert, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 3073S-o L.DÉSILETS.(P.G.10150-54) Norman & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de Ja première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit janvier 1954, constituant en corporation: Jack Lightstone, avocat, Marjorie Gilbride, Yvonne Bélanger, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements, sous le nom de \"Norman & Fils Ltée\", avec uri capital total dc $40,000 divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,500 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10038-54) O.Beaudry & Fils Limitée O.Beaudry & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1954, constituant en corporation: Paul Beaudry, Charlemagne Beaudry, Julien Beaudry, entrepreneurs, Guy Chabot, January 1954, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, Abraham M.Klein, lawyers Freda Pomerance, secretary, fille majeure, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding and investment company, under the name of \"MacGregor House Inc.\", with a capital divided into 2,000 common-shares without par value and into 1,000 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-eighth day of Januarv 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10110-54) Montarville Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January 1954, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, advocates, Freda Pomerance, secretary, fille majeure, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in as a holding and investment company, under the name of \"Montarville Investment Coq>oration\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 300 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Saint Lambert, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10150-54) Norman & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of January 1954, incorporating: Jack Lightstone, advocate, Marjorie Gilbride, Yvonne Bélanger, secretary, filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Norman & Fils Ltée\", with a total capital stock of $40,000 divided into, 1,500 common shares of $10 each and into, 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office fo the Attorney General, the twenty-eighth day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10038-54) O.Beaudry & Fils Limitée O.Beaudry & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January 1954, incorporating: Paul Beaudry, Charlemagne Beaudry, Julien Beaudry, contractors, Guy Chabot, accountant, Jean 792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1954, Tome 86, N° 10 comptable, Jean Drapeau, avocat, tous des cité et district juciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux et exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"O.Beaudry & Fils Limitée \u2014 O.Beaudry & Sons Limited\", avec un capital divisé en 10,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 9,500 actions privilégiés de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quinze janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(P.G.10147-54) Sherburn Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq janvier 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, avocats, Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Sherburn Investment Corporation\", avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.E.CANTIN.(P.G.50581-53) Sherman Dress Mfg.Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept janvier 1954, constituant en corporation: Moses Samuel Yelin, avocat, Vera Victoria Lowy, Esther Monson, secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandises composées en tout ou en partie de métal, de plastique, de textiles, de produits chimiques, minéraux, végétaux et animaux, sous le nom de \"Sherman Dress Mfg.Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.51976-53) Solor Steel Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date Drapeau, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the folllwing purposes: To carry on.business as general contractors and deal in building materials, under the name of \"O.Beaudry & Fils Limitée \u2014 O.Beaudry & Sons Limited\", with a capital stock divided into 10,000 shares without nominal or par value and 9,500 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fifteenth day of January 1954.C.E.CANTIN.36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10147-54) Sherburn Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of January 1954, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, advocates, Freda Pomerance, secretary, fille majeure, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Sehrburn Investment Corporation\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value and 900 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth day of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.50581-53) Sherman Dress Mfg.Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January 1954, incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Vera Victoria Lowy, Esther Monson, secretaries, fille majeures making use of their rights, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise made up in whole or in part, of metal, plastic, textile, and chemical, vegetable, mineral and animal products, under the name of \"Sherman Dress Mfg.Co.\", with a total capital stock of $40,000 divided into 150 common shares of a par value of $100 each and 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh day of January 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.51976-53) Solor Steel Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March Cth, 19.54, Vol.SO, No.10 793 du douze janvier 1954, constituant en corporation: Bernard Moscovitch, gérant, Gerald Rousseau, vendeur, Pauline Lcgault, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandises composées en tout ou en partie dc métal, de textiles, de plastique, de produits chimiques, minéraux, végétaux et animaux, sous le nom de \"Solor Steel Corporation Ltd.\", avec un capital total de $100,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le douze janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(P.G.10103-54) St.James Securities Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux janvier 11)54, constituant en corporation: John Austin Murphy, c.r., avocat, Edward Sinclair officier de compagnie de fiducie, Frank Dolan, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom de \"St.James Securities Ltd.\", avec un capital total de 840,000 divisé en 40,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général le vingt-deux janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-0 C.-E.CANTIN.(P.G.10145-54) Style Towne Togs, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six janvier 1954, constituant en corporation: Joseph lfelal, c.r., Samuel E.Berger, tous deux avocats, Sureka Wasscrman, sténographe, tous des cité et district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce dc vêtements, nouveautés, bijoux, quincaillerie et jouets, sous le nom de \"Style Towne Togs, Inc.\", avec un capital total de 840,000.divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.day of January 1954, incorporating: Bernard Moscovitch, manager, Gerald Rousseau, salesman, Pauline Legault, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise produced in whole or in part from metal, textile, plastic, chemial, mineral, vegetable or animal products, under the name of \"Solor Steel Corporation Ltd.\", with a total capital stock of $100,000 divided into 500 common shares of a par value of S100 each and 500 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twelfth dav of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10163-54) St.James Securities Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of January 1954, incorporating: John Austin Murphy, Q.C., advocate, Edward Sinclair, Trust company officer, Frank Dolan, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"St.James Securities Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40,000 shares of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General the twenty-second dav of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10145-54) Style Towne Togs, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of January 1954.incorporating: Joseph Helal, Q.C., Samuel E.Berger, both advocates, Sureka Wasserman, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, novelties, jewellery, hardware and toys, under the name of \"Style Towne Togs, Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 shares of S100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-sixth dav cf Januarv 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(P.G.10076-54) (A.G.10076-54) Ungava Copper Corporation Limited Ungava Copper Corporation Limited (No Personal Liability) (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des com- Notice is hereby given that under Part I of pagnies minières de la province de Québec, il a the Quebec Mining Companies Act, letters pa-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ¦ tent have been issued by the Lieutenant-Gov-province de Québec des lettres patentes, en date ernor of the Province of Quebec, bearing date the 701 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, C mars 195/,, Tome 8(i, N° 10 du quinze janvier 1954, constituant en corporation: William Ernest Regan, avocat.Vernon Frank Hownam.comptable, Colleen Shirley Abbott, secrétaire.John Edward Machines, gérant, Noël Jcnkinson, teneur de livres, tons de Toronto, province d'Ontario, pour les objets suivants: Pain des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de 'Ungava Copper Corporation Limited (No Personal Liability), avec un capital de $10,000,000, divisé en 10,000,01)0 (raclions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à 134, rue St-Jacques ouest.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1054.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.fifteenth day of January 1964, incorporating: William Ernest Regan, advocate.Vernon Frank Bowman, accountant.Colleen Shirley Abbott, secretary, John Edward Moclnness, manager, Noel Jcnkinson, book-keeper, all of Toronto, Province of Ontario, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the mime of \"Ungava Copper Corporation Limited (No Personal Liability), with a total capital stock of 810,000,000 divided into 10,000,000 shares of 81 each.The shareholders of the Company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the Company for its shares.The head office of the Company will be at 134 St.James Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fifteenth dav of January 195-1.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(P.G.51046-53) (A.G.51646-53) United Welding Processes (Canada) Inc.United Welding Processes (Canada) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province dc Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1953, constituant en corporation: Patrick Champignv, industriel, dc Laval-des-Rapides, J.-Alfred Êthier, François Morel, ces deux derniers avocats de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce dc tous produits, articles, machines et marchandises faits, (n tout ou en partie, de bois, métal, métalloïde, plastique, verre et tous les sous-produits d'iceux ainsi que les minéraux, produits chimiques et produits de la terre, de la mer et des forêts, sous le nom dc \"United Welding Processes (Can.) Inc.\", avec un capital total de 85,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trente et un décembre 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 30738-o C.-E.CANTIN.(P.G.10089-54) Wondcrwct Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt janvier 1954, constituant en corporation: Michael Garber, c.r., avocat, de West-mount.Jacob Harold Blumcnstcin, avocat, Irene Rubin, secrétaire, fille majeure, de Montréal, Manuel Shactcr, avocat, d'Outrcmout, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de savons, huiles, produits oléagineux, chimiques et détergents, sous le nom de \"Wonderwct Coq>.\", avec un capital total dc 810,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt janvier 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 36738-o C.-E.CANTIN.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December 1953, incorporating: Patrick Champigny, industrialist, of Laval-des-Rapides, J.Alfred Êthier, François Morel, both advocates, of Montreal, all of the judicial dis trict of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all products, articles, machinery and merchandise, into which enters wood, metal, mcttaloid, plastic, glass and all byproducts thereof, as well as minerals, chemical products, and products of the earth, sea and forests, under the name of \"United Welding Processes (Can.) Inc.\", with a total capital stock of 85,0000, divided into 500 shares of 810 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the thirty-first dav of December 1953.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General.(A.G.100S9-54) Wonderwet Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of January 1954, incorporating: Michael Garber, Q.C., advocate, of Westmount, Jacob Harold Blumcnstein, advocate, Irene Rubin, Secretary, fille majeure, of'Montreal, Mamie Shacter, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in soap, oils, oil-yielding and chemical products, and detergents, under the name of \"Wonderwet Corp.\", with a total capital stock of S10.000 divided into 500 common shares of 810 each and 500 preferred shares of 810 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twentieth day of January 1954.C.E.CANTIN, 36738 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1954, Vol 86, No.10 795 (P.G.5298-53) \u2022 Res La Compagnie do Téléphone Limitée de St-Germain de Grantham Dans la version française de l'avis publié dans la Gazette officielle de Québec, tome SO, N'° 9.du 27 février 1951.à la page 7oO et dans les deux pages suivantes, il y a lieu de l'aire les corrections suivantes: 1° Dans le troisième paragraphe dudit avis, soit dans le paragraphe qui commence par les mots \"ATTKNIH' QUE les personnes ci-aprè.s mentionnées.\", à noter que le dernier mot de la troisième ligne est \"requête\"; 2° Dans le septième paragraphe, le mot qui vient à la suite du nom \"Gérard Bergeron\", dans la troisième,.est \"chef-cantonnier\"; 3° Dans l'avant-dernière ligne du huitième paragraphe, au lieu de \"la compagnie de Drum-mondville\", il faut lire: \"la campagne de Drum-mondville.\" 36738-x-o (P.G.3745-52) Avis est donné que l'avis publié dans la Gazette officielle dc.Québec, tome 80, N° 9.du 27 février 195-4, à la page 700, concernant, la compagnie ci-après mentionnée, est corrigé de façon à se lire ainsi: Lusieur & Fils Inc.Lussicr & Sons Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a plu au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec dc corriger, le vingt-quatre février 1954, les lettres patentes en date du vingt-neuf mars 1952, de la compagnie \"Lussier & Fils Inc.\u2014 Lussicr & Sons Inc.\", de la manière suivante: en remplaçant, dans les mots \"et en mille actions privilégiées non cumulatives de cent dollars (8100.00) chacune portant dividende à 6% par an\", le chiffre \"6%\" par celui de \"5%\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq février 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-x-o L.DÉSILETS.(A.G.5298-53) Re: La Compagnie de Téléphone Limitée de St-Gcrmain dc Grunlham In the French version of the notice published in the Quebec Official Gazette, Volume 86, No.9, on February 27.1954, it is advisable that on pag(* 760 and the following two, corrections be made as follows: 1.In the third paragraph of said notice, that is.the paragraph commencing by the words \"'ATTENDU QUE les personnes ci-après mentionnées.\", it should be noted that the last word of the third line is \"requête\"; 2.In the seventh paragraph, the word following the name \"Gérard Bergeron\", in the third line, is \"chef-cantonnier\".3.In the line before last of the eighth paragraph, in lieu of \"la compagnie «le Drummond-ville\", read: \"la campagne de Drummondville.\" 36738-x (A.G.3745-52) Notice is hereby given that the notice published in the Quebec Official Gazette, Volume 86, No.9, dated February 27, 1954, page 760, concerning the company mentioned hereafter, is corrected in order that it should read as follows: Lusieur & Fils Inc.Lussier & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec has !>cen please to correct, on February twenty-fourth 1954, the letters patent dated March twenty-ninth 1952, of the company \"Lussicr & Fils Inc.\u2014 Lussier & Sons Inc.\", in the following manner: by replacing in the sentence \"into one thousand non-cumulative preference shares of one hundred dollars (8100.00) each, bearing a dividend of 6% per year\" the figure \"6%\" by that of \"5%\".Dated at the office of the Attorney General, the twenty-fifth dav of February 1954.L.DÉSILETS, 36738-x Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent (P.G.10205-54) (A.G.10205-54) C.-O.Monat & Compagnie Limitée C.-O.Monat & Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary Let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent have been issued by the Lieutenant-province de Québec, des lettres patentes supplé- Governor of the Province of Quebec, dated the mentaires, en date du deux février 1954, à la second day of February 1954, to the company compagnie \"C.O.Monat & Compagnie Limi- \"C.O.Monat & Compagnie Limitée\", a) L sub-tee\", a) 1.subdivisant ses 200 actions ordinaires dividing its 200 common shares of S100 into 2,000 dc 8100 en 2,000 actions ordinaires de 810 cha- common shares of S10 each; 2.decreasing its cune; 2.réduisant son capital-actions de 8120,000 shares capital of 8120,000 to S45.000: the canst 845,000: le capital-actions annulé étant divisé celled share capital being divided into 815,000 cn 15,000 actions privilégiées de 85 chacune, é- preferred shares of 85 each, issued and redeemed mises et rachetées par la compagnie; 3.augmen- by the company; 3.increasing the said share tant ledit capital-actions de $45,000 à 8120,000: capital of 845,000 to $120,000; the additional le capital-actions additionnel étant divisé en share capital being divided into 15,000 prefer-15,000 actions privilégiées de 85 chacune; b) mo- red shares of S5 each; b) modifying the clauses difiant les clauses des actions privilégiées non of unissued preference shares, encore émises.Daté du bureau du Procureur général, le deux Dated at the office of the Attorney General, février 1954.the second day of February 1954.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 36738-o L.DÉSILETS.36738 Deputy Attorney General. 796 OAZETTE OFFWI111.LE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars W5/h Tome 80, N° 10 (P.G.10240-54) Edouard Gohior, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec,des lettres patentes supplémentaires, en date du cinq février 1051,'à la compagnie \"Edouard Gohicr, Limitée\", augmentant son capital de 8200.000 » $400,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2.000 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10208-54) Frank Hatch Sims Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux février 1954, à la compagnie \"Frank Hatch Shoes Ltd.\", augmentant son capital de 840.000 à $80.000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,000 actions privilégiées de 820,000 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-p L.DÉSILETS.(P.G.10173-54) Herald \u2014 Woodward Press Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du trois février 1954, changeant le nom de la compagnie \"Woodward Press Incorporated\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du IS novembre 1932, et par lettres patentes supplémentaires en date du 13 décembre 1932, en celui dc \"Herald \u2014 Woodward Press Inc.\" Daté du bureau du Procureur général le trois février 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.-(P.G.10303-54) Joshur Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze février 1954, à la compagnie \"Joshar Incorporated\", augmentant son capital de S20.000 à 8100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 100 actions ordinaires et en 700 actions privilégiées, toutes d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le onze février 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.10190-54) Laberge & Frère (Saint-Prime) Inc.(A.G.10240-54) Edouard Gohicr, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary Letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifth day of February 1954, to the company \"Edouard Gohicr, Limitée\", increasing its capital from 8200,000 to 8400.000: the additional share capital being divided into 2,000 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, the fifth day of Februaty 1954.L.DÉSILETS,* 30738 Deputy Attorney General.(A.G.10208-54) Frank Hatch Shoes Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of t he Province of Quebec, dated February second, 1954.to the company \"Frank Hatch Shoes Ltd.\", increasing the company's capital from $40.000 to 880.000: the additional share capital being divided into 2.000 preferred shares of 820 each.Dated at the office of the Attorney General, the second dav of February 1954.' L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.10173-54) Herald- - Woodward Press Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February third 1954, changing the name of the company, \"Woodward Press Incorporated\", constituted as a corporation, under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated novembcr 18, 1932, and by Supplementary letters patent dated December 13.1932, to that of \"Herald \u2014 Woodward Press, Inc.\" Dated at the office of the Attorney General the third dav of February 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney ( Seneral.(A.G.10303-54) Joshar Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February eleventh 1954, to the company \"Joshar Incorporated\", increasing its capital from 820,-000, to 100.000: the additional share capital being divided into 100 common shares of 700 preferred shares, all of a par value of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General the eleventh day of Februarv 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10190-54) Laberge & Frère (Saint-Prime) Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, Supplementary QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, March 6th, 1954, Vol.86, No.10 7«.)7 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux février 1954, à la compagnie \"Laberge & Frère (St-Félicien) Inc.\", constituée en corporation en vertu dc ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 29 mai 1944, sous le nom originaire dc \"Milling in Transit, Ltd.\", et par lettres patentes supplémentaires en date du 2 décembre 1953, changeant, inter alia, ledit nom originaire en celui ci-haut mentionné dc \"Laberge & Frère (St-Félicien ) Inc.\", 1 ° changeant de nouveau le nom dc ladite compagnie en celui de \"Laberge & Frère (St-Primc) Inc.\"; 2° changeant l'endroit de son siège social de Saint-Félicien à Saint-Prime, district judiciaire dc Roberval.Daté du bureau du Procureur général le deux février 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DESILETS.(P.G.10206-54) Lu Compagnie des Ingénicurs-Kntrcpreneurs Limitée The Contracting-Engiiieers Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux février 1954, à \"La Compagnie des Ingénieurs-Entrepreneurs Limitée \u2014 The Contracting-Engineers Company Limited\", 1° modifiant les clauses des actions privilégiées déjà existantes; 2° subdivisant ses 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 2.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1954.L'Assistant-procureur général, 3073S-o L.DÉSILETS.(P.G.10229-54) La Ferronnerie Paradis Limitée Avis est donné qu'en vertu dc lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du cinq février 1054, changeant le nom de la compagnie \"Les Marchands dc Fer dc Mont-Joli.Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 29 mars 1940, en celui de \"La Ferronnerie Paradis Limitée\".Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1954.L'Assistant-procureur général.30738-o L.DÉSILETS.(P.G.10209-54) Les Chalets Chambly sur Richelieu Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-sept janvier 1954.à la compagnie \"Les Chalets Chambly sur Richelieu Limitée\", augmentant son capital de $25.000 à $100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 actions privilégiées de $50 chacune.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February second 1954, to the company \"Laberge & Frère (St-Félicien) Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 29, 1944.under the original name of \"Milling in Transit, Ltd.\", and by Supplementary letters patent dated December 2,1953,changing, inter alia, the said original name to that of \"Laberge & Frère (St-Félicien) Inc.\", 1° changing again the name of said company into that of \"Laberge & Frère (St-Prime) Inc.\"; 2° changing the location of its head office from Saint Félicien to Saint Prime, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General the second dav of February 1954.* L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10200-54) La Compagnie des Ingénieurs-Entrepreneurs Limitée The Con trading-Engineers Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.suppléa entary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February second 1954.to \"La Compagnie des Ingénieurs-Entrepreneurs Limitée \u2014 The Contracting-Engineers Company Limited\", I.modifying the clauses of the existing preference shares; 2.subdividing the company's 200 common shares of a par value of $100 each into 2.000 common shares of a par value of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, the second dav of February 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.10229-54) La Ferronnerie Paradis Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated Fabruary fifth.1954.changing the name of the company \"Les Marchands de Fer dc Mont-Joli.Limitée\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated March 29, 1946.to that of \"La Ferronnerie Paradis Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, the fifth day of February 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10209-54) Les Chalets Chambly sur Richelieu Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-seventh day of January 1954, to the company \"Les Chalets Chambly sur Richelieu Limitée\", increasing its capital of $25,000 to $100,000: the additional share capital being divided into 1,500 preferred shares of $50 each. 798 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, mars 1954, Tome 86, A7° 10 Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-sept janvier 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10060-54) Prolab Construction Ltée Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «!«\u2022 Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date du deux février 1954, changeant le nom de la compagnie \"Terrebonne Construction Ltée \u2014 Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions «le ladite première partie de la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes en date «lu \"> février 1953, en celui dc \"Prolab Construction Ltée \u2014 Ltd.\" Daté du bureau «lu Procureur général le deux février 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.10207-54) Robert Théberge Ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux février 1954, changeant le nom dc la compagnie \"l1'redette & Théberge Ltée \u2014 Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du vingt-quatre septembre 1952, en celui de \"Robert Théberge Ltée.\".Daté «lu bureau du Procureur général le deux février 1954.L'Assistant-procureur général.30738-o L.DÉSILETS.(P.G.10221-54) Sladen (Quebec) Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province dc Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trois février 1954.à la compagnie \"Sladen (Québec) Limited\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu des dispositions «le la Loi des compagnies minières «le Québec, par lettres patentes en date «lu II août 1937, et par let très patentes supplémentaires en date du 25 janvier 1952, 1° augmentant son capital de $400,000 à $1,500,-000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,100,000 actions de SI chacune; 2° réduisant le nombre «le ses directeurs de sept (7) à cinq (5); 3° changeant l'endroit «lu siège social «le ladite compagnie «le Montréal à Noranda, dans le district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté «lu bureau du Procureur général le trois février 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.10194-54) St.Michel Dry Cleaners Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit février 1954, chan- Dated at the office of the Attorney General, the twenty-seventh dav of Januarv 1954.L.DÉSILETS, 3073S Deputy Attorney General.(A.G.10060-54) Prolab Construction Ltée- -Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Qucbec.dated February second, 1954, changing the name of the company \"Terrebonne Construction Ltée \u2014 Ltd\", constituted as a corporation under the provisions of said Part I «)f the Quebec Companies' Act, by letters patent dateil February 5, 1953.to that of \"Piolab Construction Ltée \u2014 Ltd.';' Dated at the office of the Attorney General tin- second dav of February 1954.L.DÉSILETS.3(5738 ' Deputy Attorney General.(A.G.10207-54) Robert Théberge Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February second, 1954, changing the name of the Company \"Fredctte P Théberge Ltée \u2014 Ltd\"., constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated the twenty-fourth day of September 1952, to that of \"Robert Théberge Ltée\".Dated at the office of the Attorney General the second dav of February 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.10221-54) Sladen (Quebec) Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the third day of February 1954.to the company \"Sladen (Quebec) Limited\" (No Personal Liability), constituted as a corporation under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, by letters patent dated August 11, 1937.and by supplementary letters patent dated Januarv 25, 1952.1° increasing its share capital «>f $400,000 to SI,500,000; the additional share capital being divided into 1,100,000 shares of SI each; 2° decreasing the number of its «li-rectors from seven (7) to five (5); 3° changing the location of the head olfice of the said company from Montreal t«> Noranda, in the judicial district «>f Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, the third day of February 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.10194-54) St.Michel Dry Cleaners Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec dated February eighth 1954, changing the name of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March Gth, 1954, VpL 86, No.10 799 géant le nom de la compagnie \"St.Michael's Dry Cleaners Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 2 juillet 1953, en celui de \"St.Miche] Dry ('learners Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-o L.DÉSILETS.company \"St.Michael's Dry Cleaners Limited\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated July 2.1953, to that of \"St.Michel Dry Cleaners Limited\".Dated at the office of the Attorney General, the eighth day of February 1954.L.DÉSILETS.3673S Deputy Attorney General.Avis divers (P.G.10158-53) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 30 juillet 1953\", les règlements comprenant les articles là20 inclusivement de ('\"Association des Résidents du Quartier 'Paie Deamond' \", et ce, conformément aux dispositions «le l'article 225 «le la Loi des compagnies «le Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 31 juillet 1953.Le Sous-secrétaire «le la province, 30740-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.49046-53) Car Accessories Limited Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs «le trois à quatre: \"Que le nombre des directeurs dc la compagnie soit augmenté à quatre.\" Certifié vraie copie du règlement dé'crété par les directeurs le 4 janvier 1954, et sanctionné à l'unanimité à une assemblée générale spéciale «les actionnaires tenue le même jour.Le Secrétaire, 36741 SAUL GERSON.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation «l'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Grand-Remous\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le quinze juin 1953.Le siège social «lu syndicat professionnel précité est situé à Grand-Remous, dans le comté «le Gatineau.Le Sous-secrétairc «le la Province, 36742-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration «le fondation du syndicat coopératif \"St.Willibrord Parish Credit Union\", en «late du seize février 1954.dont le siège social est situé à Verdun, dans le dis-trict judiciaire de Montréal, et que ce «locument a été déposé dans le» archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire «le la Province, le vingt-deux février 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 36743-o JEAN BRUCHÉSI.Miscellaneous Notices (A.G.10158-53) Notice is hereby given that upon the recommendation of the deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved, on July 30, 1053.the By-laws including articles 1 to 20 inclusive, of \"Association des Résidents du Quartier 'Parc Deamond' \", and such pursuant to the provisions of Section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, July 31, 1953.J KAN BRUCHÉSI, 30740 Under Secretary of the Province.(A.G.49040-53) Car Accessories Limited By-Law increasing the number fo Directors from three to four: \"That the number of Directors of the Company be increased to four.\" Certified true copy of By-law enacted by the Directors on January 4th, 1954 and sanctioned unanimously at a Special General Meeting of the Shareholders held the same day.SAUL GERSON, 30741 -o Secretary.NOTICE (Professional .Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat «le l'U.C.C.de Grand Remous\" for the study, «lefence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June fifteenth, 1953.The principal place of business of the said professional syndicate is at Grand-Remous, in the county of Gatineau.JEAN BRUCHÉSI, 36742 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original «)f the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"St.Willibrord Parish Credit Union\" under date the sixteenth day of February 1954, -whereof the head office is at Verdun, in the judicial district of Montréal ami that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-second day of February 1954.JEAN BRUCHÉSI.36743 Under Secretary of the Province. 800 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 195/,, Tome 8C>, N° 10 AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat Patronal des Maîtres Imprimeurs de l'Ouest de la Province de Québec \u2014 Employing Printers' Syndicate of Western Quebec\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le dix-neuf février 11)54.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Hull, dans le district judiciaire dc Hull.Le Sons-secrétaire de la Province, 36744-0 JEAN BRUCHÉSI.À VIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.telles qu'ajoutées par la loi 11 George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le sept janvier 1954, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"L'Union Nationale Catholique des Mécaniciens de Machines Fixes des Trois-Rivières\", dont la formation a été autorisée le 31 octobre 1934, avec son siège social aux Trois-Rivières.dans le district judiciaire des Trois-Rivières.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-cinq février 1954.Le Sous-secrétaire de la province,' 36745-0 JEAN BRUCHÉSI.Weinstein's Inc.Règlement N° 13 Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires et n'a pas de dettes, responsabilités ou obligations qui n'ont pas été payées ou pourvues; Qu'il soit résolu: Que l'actif de la compagnie soit distribué au pro rata entre les actionnaires.Montréal, 11 février 1954.(Sceau) Weinstein's Inc.Par le Procureur de la compagnie, 30746 II.L.RAPPAPORT.Standard Equities Limited Sommaire du Règlement XLIII Que sujet aux dispositions prises aux fins de protégei toutes dettes, responsabilités ou autre obligations de la compagnie, son actif soit divisé au pro rata entre les actionnaires y ayant droits et qu'une demande soit faite subséquemment pour obtenir la permission d'abandonner la charte de la compagnie.Montréal, P.Q., le 25 févreir 1954.Les Procureurs de la Compagnie, Wainwright, Elder, Laidley, 36747-o Leslie & Bourgeois.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat Patronal des Maîtres Imprimeurs de l'Ouest de la Province dc Québec \u2014 Employing Printers' Syndicate of Western Quebec\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members has been authorized by the Provincial Secretary on February 19th, 1954, The principal place of business of the said professional syndicate is at Hull, in the judicial district of Hull.JEAN BRUCHÉSI, 36744 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professinoal Syndicates' Act) Notice is hereby given that in conformity with the provisions of section 20a of t he Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added thereto by Act 11 George VI, chapter 52, section 5, the Honourable the Provincial Secretary enacted on January seventh 1954, the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"L'Union Nationale Catholique des Mécancicns de Machines Fixes des Trois-Rivières\", the formation of which had been authorized on October 31, 1934, with head office at Trois-Rivières, in the judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-fifth dav of February 1954.JEAN BRUCHÉSI, 36745 Under Secretary of the Province.Weinstein's Inc.By-Law No.13 Whereas the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding-up its affairs and has no debts, liabilities, or obligations that have not been paid or provided for; Be it resolved: That the assets of the Company be distributed rcteably among the Shareholders.Montreal, February 11, 1954.(Seal) WeinsTein's Inc.N.L.RAPPAPORT, 3()746-o Attorney for the Company.Standard Equities Limited Summary of By-Law XLIII That, subject to due provision being made for the protection of any outstanding debts, liabilities or other obligations of the Company the assets thereof be divided rateably amongst the shareholders entitled thereto and subsequent thereto application be made for le vac to surrender the Charter of the Company.Montreal, P.Q., February 25th, 1954.Wainwright, Elder, Laidley, Leslie & Bourgeois, 36747-o Attorneys for the Company.Avis est par les présentes donné (pie l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Rouyn Area Steel- Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Rouyn QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 195/,, Vol.86, No.10 801 workers Credit Union\", en date du 28 janvier 1954, dont le siège social est situé à Houyn, dans le district judiciaire de Rouyn-Noranda, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le dix-neuf février 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 36754-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.47(558-53) Laurent Molini Int.Règlement N° 25 Sur proposition dûment faite, secondée et adoptée à l'unanimité, il a été résolu ce qui suit: Que le nombre des directeurs dc cette compagnie soit augmenté de trois à six.Décrété ce 23e jour de janvier 1954.Témoin: Le sceau de la compagnie.Le Président, LAURENT MOLINI.Le Secrétaire, 30753 JEAN DUBOCAGE.Avis d'érection en municipalité de ville Le conseil de la municipalité du village dc Ste-Anne de Chicoutimi, comté dc Chicoutimi, province de Québec, donne par les présentes avis dc son intention d'ériger la municipalité du village de Sainte-Anne de Chicoutimi en Municipalité de Ville.a) Le nom dc municipalité projetée sera \"La Ville de Chicoutimi-nord\"; b) Le territoire dc ladite municipalité de ht ville de Chicoutimi-Nord comprendra-: \"Les lots, un à six inclusivement de premier rang est du plan officiel du village dc Sainte-Anne de Chicoutimi; et des lots no 7 à 143 inclusivement du premier rang ouest du plan officiel du village de Sainte-Anne dc Chicoutimi; des lots N° 9a, 10a, 10b, 10c, lOd et 10e et.lOf du premier rang ouest du canton Tremblay faisant maintenant, partie du village de Sainte-Anne «le Chicoutimi; des lots N° lb-l à lb-23 inclusivement «lu premier rang est «lu Canton Tremblay faisant maintenant partie «lu village «le Sainte-Anne de Chicoutimi.Elle est bornée comme suit: au nor«l par les terres «lu rang 3 du Canton Tremblay et au nord est par le lot 1 b du rang 1 est «lu Canton Tremblay, à l'est par les lots I-b et 1-a du premier rang est «lu Canton Tremblay, au sud par la rivière Saguenay.à l'ouest par le lot N° 11b «lu premier rang ouest du Canton Tremblay et nord ouest par les lots 32 et 33c du 2ième rang ouest du Canton Tremblay\".c) Le recensement «le la population du village «le Sainte-Anne de Chicoutimi s'établissait à 3,903 (trois mille neuf cent soixante-trois) âmes, tel «pic constaté par un recensement ordonné par le conseil le 2 janvier 1951 et nous certifiions par la présente que la population n'a cesser d'augmenter depuis ce temps.d) L'érection de la municipalité de la ville de Chicoutimi-Nord se fera sous l'empire de la Loi des Cités et Villes, Ch 233 S.R.P.Q.1941 et ses amendements.Et le présent avis est publié à toutes fins (pie de droit.Ste-Anne de Chicoutimi, le 24 février 195-1.Le Secrétaire-trésorier de la Municipalité du village dc St-Anne de Chicoutimi, 36757-10-4-o DAVID BOUCHER.Area Stcelworkers ('redit Union\", under date the twenty-eighth day of January 1954, whereof the head office is at Rouyn, in the judicial district of Rouyn-Noranda, and that the said document has been file«l in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this nineteenth dav of February 1954.JEAN BRUCHÉSI, 30754 Under Secretary of the Province.(A.G.47058-53) Laurent Molini Inc.By-law No.25 On motion duly made, seconded ami unanimously carried, it was resolved as follows: .That the number of the directors of this Company be increaseil from three to six.Enacted this 23rd day of January, 1954.Witness: the seal of the Company.LAURENT MOLINI, President.JEAN DUBOCAGE, 36753-0 Secretary.Notice of erection of a town Municipality The Council of the Municipality of the Village of Ste.Anne dc Chicoutimi, County of Chicoutimi.Province of Quebec, hereby gives notice of its intention of erecting the Municipality of the Village of Sainte Anne de Chicoutimi into a town municipality.a) The name of the proposed town municipality shall be \"La Ville dc Chicoutimi-Nord\"; b) The territory of the said municipality of the town of Chicoutimi-North shall include: \"Lots one to six inclusive of Range one east, of the official plan of the Village of Sainte Anne de Chicoutimi; and lots No.7 to 143 inclusive of Range one west, of the official plan of the village of Sainte Anne de Chicoutimi.lots No.9a, 10a, 10b, 10c, 10(1.10e and lOf, of Range one west, of the township of Tremblay, presently forming part of the village of Sainte Anne de Chicoutimi; lots No.lb-l to Lb-23 inclusive of Range one east of the Township of Tremblay presently forming part «)f the village of Ste.Anne dc Chicoutimi.The boundaries are as follows: north by the lands of Range 3 of Township Tremblay and north-east by words lot lb of Range east.of the Township of Tremblay, cast, by words lots 1-b and la of Range one est, of the Township of Tremblay, south by words the Saguenay River, west words by lot No.1 lb of Range one west, of the Township of Tremblay and north-west words by lots 32 and 33c of Range two west, of the Township of Tremblay\".c) The population of the village of Sainte Anne de Chicoutimi was established at 3.963 (three thousand nine hundred and sixty-three) souls.as a result ofva census ordered by the Council on January 2.1951, and we hereby certify that the population has not stopped increasing since that date.d) The erection of the Municipality of the Town of Chicoutimi-North will be carried out under the Cities and Towns Act, chap.233, R.S.Q.1941, and amendments.And said notice is published for all legal purposes.Ste Anne de Chicoutimi, February 24, 1954.DAVID BOUCHER, Secretary-Treasurer, of the Municipality of the Village of Ste.Anne 36757-10-4 «le Chicoutimi. 802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 6 mars 1964, Tome 86, N° 10 (P.G.46261-53) Avis est, par les présentes, donné «pic sur la recommandation de l'Assistant Procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a.le premier mars 1954, approuvé les règlement un à dix inclusivement de \"( 'liaiitccler Curling & Country Club\", conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi «les Compagnies dc Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 2e jour de mars 1954.Le Sous-secrétaire de la Province.36760 JEAN BRUCHÉSI.Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné (pie l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le neuf février 1954, le changement du nom du \"Syndicat Patronal de la Coiffere du district de St-François\", dont la formation a été autorisée le 10 avril 1940, et le siège s< cial, fixé à Sherbrooke, dans le district de St-François, en celui de \"Association Patronale de la Coiffure du District de St François\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels.Donné au bureau du Secrétaire de la province le dix février 1954.Le Sous-secrétaire de la province, 30765-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.16200-53) AVIS Copie certifiée du règlement spécial \"B\" de \"Progressive Color & Chemical Co.\", adopté à une assemblée des directeurs de Progressive Color Si Chemical Co., tenue à 11.00 heures a.m., le 28 janvier 1954, et approuvé, ratifié et confirmé à l'unanimité à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie tenue à son siège social le 28 janvier 1954 à 11.30 heures a.m.(A.G.46261-53) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-laws one to ten inclusive of \"( haiitcelcr ( tor-ling & Country Club\", were approved on the first day of March, 1954, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the 2nd dav of March, 1954.JEAN BRUCHESI, 36760-o Under-Secretary of the Province.Notice of chance of name (Professional Syndicates Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, on February ninth 1954, approved the changing of the name of the \"Syndicat Patronal de la Coiffure du district de St.François\", the formation of which has been authorized on April tenth 1940, and head office fixed at Sherbrooke, in the district of St.Francis, to that of \"Association Patr.malc de la Coiffure du district de St-François\", and such, pursuant to the provisions of section 7 and the following, of the Professional Syndicates Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the tenth dav of February 1954.JEAN BRUCHÉSI, 30705 Under Secretary of the Province.(A.G.10200-53) NOTICE Certified copy of Special By-law \"B\" of \"Progressive Color & Chemical Co.,\" adopted at a meeting of Directors of Progressive Color & Chemical Co., held at 11.00 a.m.on January 28th, 195-1, and unanimously approved, ratified and confirmed at a special general meeting of shareholders of the Company, held at its Head Office on January 28th, 1954, at 11.30 a.m.Règlement spécial \"B\" Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de cinq à sept, et que le règlement N° 11 des règlements généraux de la compagnie amendé par le règlement spécial \"A\" daté du 8 octobre 1953, soit et il est, par les présentes, amendé dc nouveau en changeant le mot \"cinq en \"sept\".Vraie copie certifié.17 février 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 30707 LILY BUEHLER.AVIS -X» (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Médecins-Chirurgiens en Pratique Général du District Médical St-François\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux dc ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le douze janvier 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sherbrooke, dans le district judiciaire de Saint-François.Le Sous-secrétaire de la Province.30772-o JEAN BRUCHÉSI.Special By-law \"B\" That the number of Directors of the company be increased from five to seven, and that Bylaw No.11 of the general by-laws of the company, amended by Special By-law \"A\" on October 8th,.1953.be and it is hereby further amended by changing the word \"five\" to \"seven\".Certified true copy.February 17th., 1954.(Seal) LILY BUEHLER.30707-o Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Médecins-Chirurgiens en Pratique Générale du District Médical St-François\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on January twelfth 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Sherbrooke, in the judicial district of St.Francis.JEAN BRUCHÉSI, 30772 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, March 6th, 1954, Vol.86, No.10 803 (P.G.13907-52) (A.G.13907-52) La Compagnie Paquet, Limitée La Compagnie Paquet, Limitée Extrait des minutes de la soixante-et-dixième Excerpt from the minutes of the seventieth assemblée des actionnaires, assemblée spéciale meeting of shareholders, a special meeting duly dûment convoquée de La Compagnie Paquet, convened of \"La Compagnie Paquet, Limitée\" Limitée, tenue au siège social de la compagnie held at the head office of the company, at Quell Québec le 20 février 1951, concernant l'aug- bec, the 20th day of February 1951, concern-mentation du nombre des directeurs de neuf à ing the increasing of the number of Directors douze: from nine to twelve: \"Le Secrétaire donne lecture des amendements The Secretary gives lecture of amendments aux règlements Nos I et 4, tel que ci-desssous to by-laws Nos.1 and 4, as indicated herein- indiqué: under: Que le nombre des Directeurs soit augmenté That the number of Directors be increased de neuf (9) à douze (12), que le nombre des from nine (9) to twelve (12), that the number Directeurs dans les classes A.B et C soit porté of Directors in classes A, H et C be increased de trois (3) à quatre (4); que le quorum des as- from three (3) to four (4); that quorum at meet- semblées du Bureau de Direction soil porté de ings of the Hoard of Directors be increased from cinq (5) à sept (7).I es règlements N° I article five (5) to seven (7).By-laws No.1 article 8 8paragraphe5et 6N°4article 1 paragraphe3,ar- paragraph 5 and 0.No.4 article 1 paragraph tide 2 paragraphe 3.article 3 paragraphe 3.sont 3 article 2 paragraph 3.article 3.paragraph 3.par les présentes amendés comme suit: Le rè- are hereby amended as follows: By-law No.1 glement N°l article 8 paragraphe 5 en chan- article S paragraph 5 by changing number nine géant le nombre neuf (9) pour le remplacer par (9) and replacing it by that of twelve (12).le nombre douze (12).Le règlement N°l ar- By-law No.1 article 8 paragraph 6 by changing tide 8 paragraphe 0 en changeant le nombre number (5) and replacing it with that of seven cinq (5) pour le remplacer par le nombre sept (7).(7).By-law No.4 article 1^ by changing, in Le règlement N'° 4 article 1 en changeant dans the last paragraph, number three (3) and re- le dernier paragraphe le nombre trois (3) pour placing it by that of four (4).By-law No.4 le remplacer par le nombre quatre (4).Le article two (2) by changing, in the last paragraph, règlement N° 4 article deux (2) en changeant number three (3) and replacing it by that of dans le dernier paragraphe le nombre trois (3) four (4).By-law No.4 article 3 by changing pour le remplacer par le nombre (4).in the last paragraph, number three (3) and replacing it by that of four (4).Les présents amendements sont approuvés The said amendments are unanismously ap- à l'unanimité conformément à la loi et aux rè- proved in acc relance with the law and the by- glcmcnts de la Compagnie.Ces amendements laws of the Company.These amendments ont été soumis aux Directeurs à une assemblée were submitted to the Directors at a meeting tenue le 3 février 1954 et approuvée à une as- held February 3rd, 1954, and approved at a semblée des Directeurs tenue le 8 février 1954.\" Directors meeting held February 8th, 1954.\" Vraie copie conforme au livre des minutes.Certified true copy of minute book.(Sceau) La Cie Paquet Ltée, (Seal) La Cie Paquet Ltée, Par: Le Secrétaire.(Signed) Per: M.LAURIN, 307G8-o (Signé) M.LAURIN.30708 Secretary.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Avis est.par les présentes, donné (pie la com- Notice is hereby given that \"Weinstein's Inc.\", pagnie \"Weinstein's Inc.\".constituée en corpo- incorporated by letters patent, of the Province of ration par lettres patentes de la province de Quebec, dated January 15, 1948, under the name Québec, en date du 15 janvier 1948.sous le nom of Weinstein's (Victoriaville) Inc., will make app- de Weinstein's (Victoriaville) Inc., demandera la plication for leave to surrender its Charter, permission d'abandonner sa charte.Montréal.11 février 1954.Montreal.February 11, 1954.(Sceau) Le Procureur de Weinstein's Inc.(Seal) N.L.RAPPAPORT.30740 N.L.RAPPAPORT.30740-O Attorney for Weinstein's Inc.Standard Equities Limited Standard Equities Limited Avis est.par les présentes, donné (pie \"Standard Equities Limited\" a l'intention de démander la permission d'abandonner sa charte conformément à la Loi des compagnies de Québec.Montréal, P.Q., le 25 février 1954.Les Procureurs de la Compagnie, WAINWRIGHT, ELDER, LAIDLEY, 30747-o LESLIE & BOURGEOIS.Avis de demande d'abandon de Charte Avis est par la présente donné que \"Grand Investment Co\", une corporation établie sous Notice is hereby given that \"Standard Equities Limited\" intends to apply for leave to surrender its Charte* in accordance with the Quebec Companies' Act.Montreal.P.Q.Februarv 25th, 1954.WAINWRIGHT, ELDER.LAIDLEY, LESLIE & BOURGEOIS.30747-o Attorneys for the Company.Notice of Leave to Surernder Charter Notice is hereby given that \"Grand Investment Co\", a corporation constituted in accor- SOI GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 6 mars 1964, Tome 86, N° 10 la Loi «les Compagnies «lu Quebec, s'adressera au Procureur général «le la Province «le Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions «le la Loi «les Compagnies «lu Québec.Daté à Montreal, le 22/2/54 Le Procureur pour Grand Investment Company, LUCIEN LEGER, 36748-0 3518 rue Durocher, Montréal.Hardy Electronics & Supplies Ltd.Avis d'abandon de charte La compagnie \"Hardy Electronics & Supplies Ltd.\", par son procureur soussigné, donne avis qu'elle s'adressera à l'honorable procureur général de la province «le Québec et présentera conformément aux dispositions «le la Loi «les Compagnies «le Québec une requête pour être autorisée à abandonner sa charte.Montréal, le 1er mars 1954.Le Procureur «le la compagnie.Hardv Electronics & Supplies Ltd.30756-o F.EUGENE THERRIEN.«lance with the Quebec Companies' Act, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec in order to obtain leave to surrender its charter pursuant t«» the provisions of the Quebec ( !ompanies' Act.Dated at.Montreal, February 22.1954.LUCIEN LEGER, Attorney for Grand Investment Company.36748 3518 Durocher Street, Montreal.Hardy Electronics & Supplies Ltd.¦Notice ok surrender of charter The Company \"Hardy Electronics & Supplies Ltd.\", by the undersigned Attorney, hereby gives notice that application will be made to the Honourable the Attorney General of the Province of Quebec, rcipiesting leave to surrender the Company's charter, and such, pursuant to the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, March 1st, 1951.F.EUGENE THERRIEN, Attorney for the Company 36756 Hardy Electronics & Supplies Ltd.Compagnies dissoutes (P.G.41104-53) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 270 article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie\" Ayers-Clilf Wood Products Limited\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 novembre 1950.Avis est de plus donné qu'à compter «lu premier mars 1954.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général le deux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(P.G.0097-53) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 270.article 20.et sujet à la responsabilité décrétée par l'aticle 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon «le la charte f the charter of the company \"Dale Securities Inc.\", constitue*! as a corporation by letters patent dated the tenth day of May 1929.Notice is also hereby given that from ami after tin- first day «>f March 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of March 1951.L.DÉSILETS, .'507.'^ Deputy Attorney General.(A.G.47014-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270.R.S.Q., 1941.ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Donear Investments Inc.\" incorporated under letters patent bearing dale March 8, 1951.Notice is also hereby given that from and after February fifteenth, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of March, 1954.L.DÉSILETS, 3073S Deputy Attorney General.(A.G.47711-53) Notice is hereby given that under Part I of the Qin4>cc Companies' Act, section 20.chapter 270.R.S.Q.1941, and subject to-the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Fifty Five Fifty Seven St.James Ltd.\", constituted as a corporation by Letters Patent dated the eighteenth day of February 1946.Notice is also hereby given thatfrom ami after the first day of March 1954, the said company has been «lissolvcd.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of March 1954.L.DÉSILETS.30738 , Deputy Attorney General.(A.G.41012-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lachine Golf & Country Club Inc.\", constituted as a corporation by Letters Patent dated the tenth day of February 1950.Notice is also hereby given that from and after the first day of March 1954.the said company has been dissolved. SOC) GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Quebec 6 mars 1964, Tome 86, N° 10 Daté du bureau du Procureur général le deux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-ù L.DESILETS.(P.G.48935-53) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte «le la compagnie \"Les Immeubles Bcrnier Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en «late «lu 15 mai 1952.Avis est.dc plus donné qu'à compter «lu premier mars 1954, la«litc compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général le deux-mars 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-o ' L.DESILETS.(P.G.49174-53) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagni«\\s «le Qut'bec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité «l«''erétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte dc la compagnie \"Louis Mintz Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 mai 1950.Avis est «le plus donné qu'à compter du premier mars 1954, laeite compagnie a été «lissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général le «leux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 3073S-o L.DÉSILETS.(P.G.0487-53) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie dc la Loi des compagnies «le Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 270.article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"Quebec Stainless Steel Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en «late du 4 novembre 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du premier mars 1954, ladite compagnie a été «lissoute.Daté «lu bureau du Procureur général le deux mars 1954.¦\u2022 L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.50483-53 Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité «lécrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon dc la charte de la compagnie \"Spring Products Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 mars 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du premier mars 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, this second day of March 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.48935-53) Notice is hereby given thai under Part I of the Quebec Companies' Act.section 20, chapter 270, R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 «>f the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Les Immeubles Bernier Limitée\" incorporated by letters patent bearing «late May 15, 1952.Notice is also hereby given that from ami after March first, 1954 the sai«l company has been dissolve* 1.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of March, 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.49174-53) Notice is hereby given that umlcr Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Louis Mintz Inc.\", constituted as a corporation by Letters Patent dated the twenty-fifth day of May 1950.Notice is also hereby given that from and after the first day of March 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this secoml dav «)f March 1954.L.DÉSILETS, 36738 Deputy Attorney General.(A.G.9487-53) Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270.S.R.Q., 1941.ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Quebec Stainless Steel Ltd.\" incorporated by letters patent on November 4, 1948.Notice is also hereby given that from and after March first, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of March, 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.50483-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, jfiid subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Spring Products Limited\", constituted as a corporation by Letters Patent, dated the twenty-fourth day of March 1950.Notice is also hereby given that from and after the first day of March 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of March 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 1964, Vol.80, No.10 807 (P.G.10170-53) Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts retondus de Québec, 1041, chapitre 270.article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon dc la charte de la compagnie \"The New Frontenac Glass Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 18 décembre 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du premier mars 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.50252-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte dc la compagnie \"Tremblay Express Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 29 août 1947.Avis est de plus donné qu'à compter du premier mars 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 30738-o L.DÉSILETS.(P.G.41170-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Wilshire Textiles Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes en en «late du 23 février 1946.Avis est dc plus donné qu'à compter du premier mars 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux mars 1954.L'Assistant-procureur général, 36738-0 L.DÉSILETS.(A.G.10170-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270.R.S.Q., 1941.and subject to the liability, enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"The New Frontenac Glass Co.Ltd.\".constituted as a corporation by Letters Patent dated the eighteenth day of December 1948.Notice is also hereby given that from and after the first day of March 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of March 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.50252-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Tremblay Express Limitée\" incorporated by letters patent under date of August 29, 1947.Notice is also hereby given that from and after March first, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of March, 1954.L.DÉSILETS, 30738 Deputy Attorney General.(A.G.41170-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20.chapter 270.R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General, has been pleased to accept, the surrender of the charter of the company \"Wilshire Textiles Incorporated\" incorporated by letters of February 23, 1946.Notice is also hereby given that from ami after March first, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of March, 1954.L.DÉSILETS, 3673S Deputy Attorney General.Curatelle publique Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Succession vacante de Joseph Boutct, En son vivant journalier de la paroisse de Jacques-Cartier dans la cité de Québec.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 7 novembre 1952 par un juge de la cour supérieure siégeant à Québec dans le district de Québec que, sous l'autorité dc la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.02), il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC, 187, rue Sainte-Catherine (Ouest), 36762-0 Montréal 18.Public Curatorship Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Vacant Estate of Joseph Boutet, in his lifetime day-labourer, of the parish of Jacques Cartier, in the City of Quebec.The undersigned hereby gives notice that this estate has been declared vacant by judgment rendered November 7, 1952, by a judge of the Superior Court sitting at Quebec in, the district of Quebec, and that under authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI, c.62), he is Curator ex officio of said estate and, shall receive, at the address mentioned herein-under, payment of all debts owing to said estate and proof of any claim against it.THE PUBLIC CURATOR, 187, Saint-Catherine Street (West), 36762 Montreal 18. 808 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 6 mars 105/,, Tome 86, N° 10 Département de l'Instruction publique *N° 162-54.Québec, le 12 févrjer 1954.Demande est faite que le nom «le la municipalité scolaire «le Stukely-Nord, dans le comté «le Shefford, soit changé en celui «le \"Bonsecours\", même comté.l.e Surintendant de l'Instruction publique, 30720-9-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 12-54.Québec, le 1S février 1954.Demande est faite «le former en municipalité smlaire distincte, sous le nom dc \"Chibouga-mau\" comté d'Abitibj-est, le territoire «lu village minier «le Chibougamau, non organisé au point de vue scolaire.Le territoire de cette future municipalité scolaire est décrit comme suit, savoir: l'ii territoire faisant partie des cantons «le McKenzie et Obalski et dont les limites se «lc-crivent comme suit: Parlant «lu point «l'intersection «le la ligne separative «les rangs VIII et IX «lu canton «le Obalski avec la ligne separative «les lois 13 et 14 du rang IX «ludit canton: «le là passant successivement par: la ligne separative «les lots 13 et 14 «les rangs IX et X du canton de Obalski et la ligne separative des lots 13 et 14 «les rangs I, II.III.IV.«lu canton de McKenzie.la dernière prolongée jusqu'à la ligne separative «les rangs V et VI; ladite ligne separative «les rangs V et VI dans la direction est astronomique jusqu'à un point situé à trois milles à l'est «le la ligue «\u2022eutraie; une ligne «lans la direction Sud astronomique jusqu'à la ligne separative «les rangs VIII et TX «lu canton «le Obalski; ladite ligue separative «les rangs VIII et IX du canton de Obalski dans la direction ouest astronomique jusqu'au point «le départ; lequel territoire ensemble avec les chemins, rues, ruelles, rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites ci-dessus the land of Moïse Trépanier, which bounds it on the South, the said emplacement bounded in front on the North side by the Public Highway, in rear, on the South, by the lain! of Moïse Trépanier, «>n one side, on the East, by the emplacement of Dame Marie Clermont and partly by the church property of St-Martin and on the West side by other parts of the same lots.To be soldat the parochial church door of the parish of St-Martin, county of Laval, APRIL EIGHTH, 1954, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office.Sheriff.Montreal, March 2, 1954.30703-10-2 QUEBEC Fieri Facias Magistrate's Court Quebec, to wit : / TRADERS FINANCE No.108907.^ A CORPORATION LI-l MITED, a body politic and corporate, having an office at 400 Boulevard Charest.Quebec, vs EUGENE THIBAULT of Ste.Catherine, Village, County of Portneuf, to wit: Part of lot No.340 (three hundred and forty-six, part) of official cadastre of the Parish of St. 826 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars 1954, Tome 86, N° 10 Catherine, comté de Portneuf, étant un emplacement situé à Ste-Catherinc, mesurant 60 pieds de largeur sur 120 pieds de profondeur, le tout plus ou moins, borné au nord et à l'ouest par Louis-Arthur Drolet ou représentant, au sud parle chemin du cinquième rang et à l'est par Albert Le-vebvre ou représentant, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale dc Ste-Catherine, comté de Portneuf, le VINGT-SIXIEME jour de MARS prochain, à DIX heures du matin.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, ALBERT F.RACETTE.Québec, 17 février 1954.36703-8-2-O [Première insertion: 20 février 1954.] JDeuxième insertion: 0 mars 1954.] Fieri Facias Québec, à savoir: t T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 71865.\\ ¦¦-« AGRICOLE DU QUÉ-( BEC, corps politique et incorporé avant son siège social à Québec, contre EDDY SALVAS, de la Croche via La Tuque, comté de Laviolette, P.Q., à savoir; Une terre située en la paroisse de La Croche, comté de Laviolette, de la contenance en superficie de cent acres, connue et désignée comme étant la partie est du lot numéro 46 (quanrante-six), rang ouest, partie 40 (quanrante-six) aux plan et livre dc renvoi officiels du cadastre fait pour le canton Langelier, comprise dans les bornes suivantes: à l'ouest par le lot numéro 93 (quatre-vingt-treize), à l'est par la rivière La Croche, au sud par le lot numéro 45 (quarante-cinq), et la Rivière La Croche; Une terre située au même endroit, de la contenance en superficie de cent Acres, connue et désignée comme étant la partie est du lot No 47 (quaiante-sept), rang ouest partie 47 (quarante-sept) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre fait pour le canton Langelier, bornée à l'ouest par le N° 93 (quatre-vingt-treize), à l'est i ar la ii\\ ière La Croche, au sud par le N° 40 (quarante-six) et au nord par le N° 48 (quarante-huit); Une terre située au même endroit de la contenance en superficie de soixante-quinze Acres, connue et désignée comme étant la partie est du lot N° 48 (quarante-huit) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre fait pour le canton Langelier, borné à l'ouest par le lot N° 93 (quatre-vingt-treize), à l'est par la rivière La Croche, au sud par le N° 47 (quarante-sept), et au nord par le lot N° 49 (quarante-neuf); Le tout avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Poui être vendues \"en bloc\" au Bureau d'Enregistrement de la Ville De La Tuque, comté de Laviolette, le VINGT-SIXIEME jour dc MARS prochain, à DIX heures du matin.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, ALB.F.RACETTE.Québec.17 février 1954.3G702-S-2-O [Première insertion: 20 février 1954.] [Deuxième insertion: 6 mars 1954.] RIMOUSKI Fieri Facius dc Terris Canada Province de Québec District de Rimouski Cour de Magistrat./ CHARLES A JOU-N° 25,540.j ^ BERT & AL, Qué-\\ bec demandeurs vs ANTOINE LA BRIE, domicilié à Ste-Paula dans le district de Rimouski défendeur.Catherine, County of Portneuf, being an emplacement situate at St.Catherine, measuring 60 feet in width by 120 feet in depth, all of which more or less, nounded to the north and west by Louis-Arthur Drolet or representative, south by the road of Range five, and east by Albert Lefeb-vre or representative, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Ste.Catherine.County of Portneuf, the TWENTY-SIXTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the morning.ALBERT F.RACETTE.Sheriffs Office, Deputy Sheriff.Quebec, February 17, 1954.30703-8-2 [First inscrtionL: February 20, 1954] [Second insertion' March 0, 1954.] Fieri Facias Quebec, to wit: / /QUEBEC FARM CREDIT No.71865.< V£ BUREAU, a body politic \\ and corporate having its head office in Quebec; vs EDDY SALVAS, of La ('roche via La Tuque, county of Laviolette, P.Q., to wit: A farm situate in the parish of La ('roche, county of Laviolette, containing an area of one hundred acres, known and designated as being the east part of lot number 40 (forty-six), west Range, part 46 (forty-six) on the official plan and book of reference of the cadastre for the township of Langelier, included in the following boundaries: to the west by lot number 93 (ninety-three) easterly by La Croche River, southerly by lot number 45 (forty-five) and La Croche River; A farm situât \u2022 in the same locality, containing an area of 100 acres, known and designated as being the cast part of lot No.47 (forty-seven) west Rai'ge part 47 (forty-seven) on the official plan and book of reference of the cadastre for the township of Langelier, bounded westerly by No.93 (ninety-three), easterly by La Croche River, southerly by No.40 (forty-six) and northerly by No.48 (forty-eight).A farm situate in same locality containing an area of seventy-five acres, known and designated as being the east part of lot No.48 (forty-eight) on the official plan and book of reference of the cadastre for the-township of Langelier, bounded westerly by lot No.93 (ninety-three), easterly by La Croche River, southerly by No.47 (forty-seven) and northerly by lot No.49 (forty-nine) ; All of which with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold \"en bloc\" at the Registry Office of the Town of La Tuque, countv of Laviolette, the TWENTY-SIXTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the morning.ALB.F.RACETTE, Sheriffs Office, Deputy Sheriff.Quebec, February, 17 1954.30702-8-2 [First insertion: February 20, 1954.] Second insertion: March 6, 1954.] RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada, Province of Quebec, District of Rimouski Magistrate's Cou rt, / IIA R L E S A J O U-No.25,540.{ ^ BERT & AL, Que-( bee, Plaintiffs vs ANTOINE LABRTE, domiciled at Ste.Paula in the district of Rimouski.defendant. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.March 6th, 1954, Vol.86, No.10 827 Le lot N° Hi, du rang 13.canton Matane, avec bâtisses dessus const mit es, circonstances et dépendances.Pour être vendu le 7 AVRIL 1954 au bureau d'enregistrement à Amqui à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif.36764-10-2-o < ÎHARLES ( 1AR0N.ROBERVAL Fieri Facias dc Terris ( 'anada \u2014 Province dc Québec District dc Roberval Cour de Magistrat, ( pRONOVOST & FRE-N° 18615.< r RES ENRG.demandeur vs RENÉ LAMBERT, défendeur.Le lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt-sept-B-(No 27-B-) du rang cinq (5) du canton Albanel, description cadastrale, sauf servitude en faveur de la Companie Saguenay Electrique, laquelle servitude a été enregistrée le 23 août 1946 au X° 47830 du bureau d'enregistrement de Roberval, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'Eglise de la paroisse d'Albanel, comté et district de Roberval, Province de Québec, le SIXIÈME jour d'AVRIL 1954 à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ANTOINE TREMBLAY.Palais de Justice, Roberval, ce 2 mars 1954.36766-10-2-o Loi No.Hi.Range 13.Township of Malanc with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold on the SEVENTH dav of APRIL 1954, at the Registry Office of Amqui, at.TWO o'clock in the afternoon.CHARLES GARON, 30704-10-2 Sheriff.ROBERVAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec Magistrate's Court, / pRONOVOST & FRE-No.18015.j -t RES, ENRG.plaintiff Us RENE LAMBERT, defendant.A lot of land ,nown and designated under number twciity-scven-B-(.No.27-B-) of Range five (ô) of the Township Albanel, cadastral description, save a servitude in favour of the Saguenay Electric Company, which servitude was registered on August 23, 1940 under No.47830 in the Registery Office of Roberval, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the Parish of Albanel, county and district of Roberval, Province of Quebec, the SIXTH day of APRIL 1954 at ELEVEN o'clock in the forenoon.ANTOINE TREMBLAY, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Roberval, this March 2nd, 1954.30700-10-2 SAGUENAY Canada \u2014 Province dc QiU'bcc District Saguenay Cour Supérieure., Vf VON IMBAULT.contre-N° 11892.\u2022[ A maître, résidant et domi-{ cilié à 9, avenue Dollard Baie Comeau, comté Saguenay.demandeur, vs JEAN CHARLES Tremblay, cultivateur, résidant et domicilié à Canton Latour comté Saguenay, défendeur.Un lot portant le N° 16-17 sud du Canton Latour, avec bâtisses construitent dessus circonstances et dépandances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale (hl Canton Latour MARDI le 6 AVRIL à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.PIERRE NÉRON.Fait et signé à La Malbaie ce 27 février 1954.30750-lO-2-o SAGUENAY ( 'anada \u2014 Province of Quebec District of Saguenay Superior Court, j VVON IMBAULT, foreman.No.11892.-j 1 residing and domiciled at (9, Dollard Avenue, Baie Comeau.count v of Saguenay, plaintiff, vs JEAN CHARLES TREMBLAY', farmer, residing and domiciled in the Township of Latour, county of Saguenay, defendant.A lot of land bearing No.10-17 south of the Township of Latour, with buildings thereon erected, circumstances and dependences.To be sold at the parochial church door of the Township of Latour.TUESDAY, the SIXTH day of APRIL, at TWO o'clock in the afternoon.PIERRE NÉRON.Sheriff's Office, Sheriff.Made and signed at La Malbaic, this 27th day of February, 1954.36759-10-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N' 10 Avis aux intéressés: 777 Avis divers: Association des Résidents du Quartier \"Parc Deamond\" (Règlements).799 Association Patronale de la Coiffure du District de St-Francois (Changement de nom).802 Car Accessories Limited (Directeurs).799 Clianteclerc Curling & Country Club (Règlements).802 Index of the Quebec Official Gazette, No.10 Notice to Interested Parties: 777 Miscellaneous Notices: Association des Résidents du Quartier \"Parc Deamond\" (By-Laws).799 Association Patronale de la Coiffure du District dc St-François (Change of naine).802 Car Accessories Limited (Directors).799 Clianteclerc Curling & Country Club (By-Laws).802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 6 mars 1954, Tome 80, N° 10 La Compagnie Paquet, Limitée (Directeurs).\u2022-\u2022 \u2022\u2022 803 1,\"Associât ion des Médccins-< Ihirurgiens en Pratique Générale du District Médical St-François (Formation).802 Laurent Molini Inc.(Directeurs).801 Le Syndicat dc l'U.C.C.de Grand-Remous (Formation).799 L'Union Nationale Catholique des Mécaniciens de Machines Fixes * des Trois-Rivières (Existence terminée) .800 Progressive Color & Chemical Co.(Directeurs).802 Rouyn Area Steelworkers Credit Union (Fondation).800 Standard Equities Limited (Dist.de l'actif).800 Ste-Anne dc Chicoutimi, village de (Demande d'érection).801 St.Willibrord Parish Credit Union (Fondation).799 Syndicat Patronal des Maîtres Imprimeurs dc l'Ouest dc la Province de Québec \u2014 Employing Printers' Syndicate of Western Quebec (Formation) 800 Weinstein's Inc.(Dist.de l'actif).800 ('hautes \u2014 An ax don de: Grand Investment Co.803 Hardy Electronics & Supplies Ltd.SOI Standard Equities Limited.803 Weinstein's Inc.803 Compagnies dissoutes: Ayers-Clilf Wood Products Limited .801 Begin et Pépin Liée.801 Compagnie Yanier Limitée.SOI Dale Securities Inc.805 Doncar Investments Inc.805 Fifty Five Fifty Seven St.James Ltd.805 Laciiine Golf & Country Club, Inc.805 Les Immeubles Bernier Limitée.800 Louis Mint/.Inc.800 Quebec Stainless Steel Ltd.806 Spring Products Limited.800 The New Frontenac (Mass Co.Ltd.807 Tremblay Express Limitée.807 Wilshire Textiles Incorporated.807 Curatelle publique: Boutet, Succession Joseph.S07 DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Bonsecours.802 Chibougamau.802 Terres et Forets: Service du Cadastre: Iberville, canton de.802 Iberville, canton dc.802 Travail: Industrie ou métiers de: Arrêté en Conseil numéro 101-B du 10 février 1954 \u2014 Boîte de carton dans la Province (Erratum).809 Barbier et coiffeur de Sherbrooke (Modification).810 Construction de Trois-Rivières (Modification) .809 La Compagnie Paquet, Limitée (Directors).803 L'Association des Médecins-( Chirurgiens en Pratique Générale du District Médical St-Francois (Formation).802 Laurent Molini Inc.(Directors).801 Le Syndicat dc l'U.C.C.de Grand-Remous (Formation).799 L'Union Nationale Catholique des Mécaniciens de Machines Fixes des Trois-Rivières (Existence terminated) 800 Progressive Color & Chemical Co.(Directors).802 Rouyn Area Steelworkers Credit Union (Foundation)____.800 Standard Equities Limited (Dist.of the assets).S00 Ste-Anne dc Chicoutimi, village of (Application for erection).801 St.Willibrord Parish Credit Union (Foundation).799 Syndicat Patronal des Maîtres Imprimeurs de l'Ouest de la Province de Québec \u2014 Employing Printers' Syndicate of Western Quebec (Formation).800 Weinstein's Inc.(Dist.of the assets).800 Charters \u2014 Surrender of: Grand Investment Co.803 Hardy Electronics & Supplies Ltd.804 Standard Equities Limitée!.803 Weinstin's Inc.803 Companies Dissolved: Ayers-Cliff Wood Products Limited.804 Begin et Pépin Ltée.804 Compagnie Yanier Limitée.804 Dale Securities Inc.805 Doncar Investments Inc.805 Fifty Five Fifty Seven St.James Ltd.805 Laehine Golf & Country Club.Inc.805 Les Immeubles Bernier Limitée.800 Louis Mint/ Inc.806 Quebec Stainless Steel Ltd.800 Spring Products Limited.806 The New Frontenac Glass Co.Ltd.807 Tremblay Express Limitée.807 Wilshire Textiles Incorporated.807 Public Curatorship: Boutet, Estate of Joseph.807 I)EPARTM ENTAL NOTK ES: Education: School Municipality of: Bonsecours.v.802 Chibougamau.802 Lands and Forest: Cadastral Branch: Iberville, township of.802 Iberville, township of.802 Labour: Industry or Trades of: Order in Council No.101-B of February 10, 1054 \u2014 Paper box in the Province (Erratum).809 Barber and hairdressing of Sherbrooke (Amendment).810 Construction of Trois-Rivières (Amendment) .809 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, 195/,, Vol.86, No.10 829 L'Union Nationale Catholique des Boulangers et Distributeurs dc Pain, Inc., des Trois-Rivières (Avis).SI2 Robe dans la province de Québec (Modification).811 Sacoche dans la Province (Modification) .809 Lettres patentes: Abitibi Propane Gas Co.Ltd.778 Aetna Investment Corporation Corporation de Placement Aetna.779 Barone Co.Ltd.779 Beaudry Maple Products \u2014 Les Produits d'Erable Beaudry Inc.779 Beaumont Mining Corporation Ltd.780 Bilodeau & Doré Limitée.w 780 Bungalow Construction Ltd.780 Canada Dactylographe Inc.\u2014 Canada Typewriter Inc.781 Canadian Neutral Sulphie Corporation.781 Chateau Huntingdon Incorporée \u2022 Chateau Huntingdon Incorporated.781 Club No.77.782 Delta Furs and Skin Company.782 Desnoycrs & Beauchcmin Liée.782 Eastern Canada Forest Products Inc.783 Elite Investment Corporation.783 Epicerie du Sous-Sol Ltée.783 F.Courtemanche Ltée.781 George Automobile Limitée George Automobile Limited.784 Gérard Pageau Limitée.785 Gérard Sauvageau Construction Inc.785 G.S.G.Hosiery Mills Limited.785 Hôtel New Wellington Limitée.780 Hutchins Investment Corporation.786 Joseph V.Nadler & Co.Inc.780 King Copper Mining Corporation.787 Laboratoire Cartier Inc.787 La Cie des Distributeurs Economiques Lté'c \u2014 Economie Jobbers Ltd.787 La Compagnie de Construction Mannibec Limitée \u2014 The Mannibec Construction Company Limited.788 La Compagnie dc Téléphone Limitée de St-Germain de Grantham (Corrections) .795 L'Auberge du Boulevard Ltée.788 Lauzon Drive Yourself Inc.7S8 Les Amusements Nap.Côté, Inc.789 Les Fabricants Mobilier Moderne Compagnie Ltée.789 Les Loisirs Notre Dame de Sorel Inc.789 Les Marchandises Sèches de Sherbrooke Ltée (Sherbrooke Dry Goods Ltd.) 790 Lucerne Finance Corporation Limited \u2014 La Compagnie de Finance Lucerne Limitée.790 Lussier & Fils Inc.\u2014 Lussier & Sons Inc.(Correction).795 MacGregor House lue.790 Montarville Investment Corporation .791 Norman & Fils Ltée.791 O.Beaudry & Fils Limitée \u2014 O.Beaudry & Sons Limited.791 Sherburn Investment Corporation.792 Sherman Dress Mfg.Co.792 Solor Steel Corporation Ltd.792 St.James Securities Ltd.793 Style Towne Togs, Inc.793 Ungava Copper Corporation Limited.793 United Welding Processes (Can.) Inc.794 Wonderwet Corp.794 L'Union Nationale Catholique des Boulangers et Distributeurs de Pain, Inc., des Trois-Rivières (Notice).812 Dress in the Province of Quebec (Amendment) .811 Handbag in the Province (Amendment) .809 Letters Patent: Abitibi Propane Gas Co.Ltd.778 Aetna Investment Corporation \u2014 Corporation de Placement Aetna.779 Barone < Jo.Ltd.779 Beaudry Maple Products \u2014 Les Produits d'Érable Beaudry Inc.779 Beaumont Mining Corporation Ltd.780 Bilodeau & Doré Limitée.780 Bungalow Construction Ltd.780 Canada Dactylographe Inc.\u2014 Canada Typewriter Inc.781 Canadian Neutral Sulphie Corporation.781 Chateau Huntingdon Incorporée \u2014 Chateau Huntingdon Incorporated.781 Club No.77.782 Delta Furs and Skin Company.782 Desnoycrs & Beauchcmin Ltée.782 Eastern Canada Forest Products Inc.783 Elite Investment Corporation.783 Epicerie du Sous-Sol Ltée.783 F.Courtemanche Ltée.784 George Automobile Limitée \u2014 George Automobile Limited.784 Gérard Pageau Limitée.785 Gérard Sauvageau Construction Inc.785 G.S.G.Hosiery Millsjamitcd.785 Hôtel New Wellington Limitée.786 Hutchins Investment Corporation.786 Joseph Y.Nadler & Co.Inc.786 King Copper Mining ( Corporation.787 Laboratoire Cartier Inc.787 La Cie des Distributeurs Economiques Ltée \u2014 Economie Jobbers Ltd.787 La Compagnie de Construction Mannibec Limitée \u2014 The Mannibec Construction Company Limited.788 La Compagnie de Téléphone Limitée de St-Germain de Grantham (Corrections).795 L'Auberge du Boulevard Ltée.788 Lauzon Drive Yourself Inc.788 Les Amusements Nap.Côté, Inc.789 Les Fabricants Mobilier Moderne Compagnie Ltée.789 Les Loisirs Notre Dame de Sorel Inc.789 Les Marchandises Sèches de Sherbrooke Ltée (Sherbrooke Dry Goods Ltd.) 790 Lucerne Finance Corporation Limited \u2014 La Compagnie de Finance Lucerne Limitée.790 Lussicr & Fils Inc.\u2014 Lussier & Sons Inc.(Correct ion).795 MacGregor House Inc.790 Montarville Investment Corporation .791 Norman & Fils Ltée.791 O.Beaudry & Fils Limitée \u2014 O.Beaudry & Sons Limited.791 Sherburn Investment Corporation.792 Sherman Dress Mfg.Co.792 Solor Steel Corporation Ltd.792 St.James Securities Ltd.793 Style Towne Togs.Inc.793 Ungava Copper Corporation Limited.793 United Welding Processes (Can.) Inc.794 Wonderwet Corp.794 830 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 6 mars 195/,.Tome 86, N° 10 Lettres patentes supplémentaires: C.0.Monal & Compagnie Limitée.Edouard Gohier, Limitée.Frank Hatch Shoes Ltd.Herald \u2014 Woodward Press [ne.Joshar Incorporated.Laberge & Frère (St-Primc) Inc.La Compagnie des Ingénieurs-Entrepreneurs Limitée \u2014 The Contracting-Engineers Company Limited.La Ferronnerie Paradis Limitée.Les Chalets Chambly sur Richelieu Limitée.r.Prolab Construction Ltée \u2014 Ltd.Robert Théberge Ltée.Sladen (Quebec) Limited.St.Michel Dry Cleaners Limited.Sièges sociaux: Beaumont Mining Corporation Ltd.Gérard Pageau Limitée.Oreland Mining Corporation.Zenda Realties Limited.Soumissions: Louiseville.ville dc.Senneterre, commissaires d'écoles dc.St-Basile-le-Grand, commissaires d'écoles de .St-Vincent-dc-Paul, paroisse dc.Waltham.commissaires d'écoles dc.Ventes par licitation: Chamberland vs Charbonncau et al.VENTES PAR SHÉRIFS: Bedford: Tétrcault vs Dufort.Chicoutimi: Côté Boivin Auto Service Inc.vs Lavoie Joliette: Armstrong vs Armstrong.L'Office du Crédit Agricole du Québec vs Dcsrochcrs.Kamouraska: Paroisse dc St-Bcnoît Abbé vs Ducas.Paroisse dc St-Benoît Abbé vsThériault Montréal: Saintonge vs Taillefcr.Québec: L'Office du Crédit Agricole du Québec vs Sal vas.Traders Finance Corporation Limited vs Thibault.Rimouski: Joubert et al vs Labrie.Roberval: Pronovost & Frères Enrg.vs Lambert.Supplementary Letters Patent: 795 C.O.Monat & Compagnie Limitée!.795 796 Edouard Gohier, Limitée.796 796 Frank Hatch Shoes Ltd.796 796 Herald \u2014 Woodward Press lue.796 796 Joshar Incorporated.796 796 Laberge & Frère (St-Prime) Inc.790 La Compagnie des Ingénieurs-Entre- preneiujB Limitée \u2014 The Contracting- 797 Engineers Company Limited.797 797 La Ferronnerie Paradis Limitée.797 Les Chalets Chambly sur Richelieu 797 Limitée.7! 17 798 Prolab Construction Ltée \u2014 Ltd.79S 798 Robert Théberge Ltée.798 798 Sladen (Quebec) Limited.798 798 St.Michel Dry Cleaners Limited.798 Head Offices: 814 Beaumont Mining Corporation Ltd.811 814 Gérard Pageau Limitée.814 815 Oreland Mining Corporation.815 815 Zenda Realties Limited.815 Tenders: 816 Louiseville, town of.816 819 Senneterre, School Commissioners of.819 St-Basile-le-Grand, School Commission- 815 ersof.815 817 St-Vincent-de-Paul, parish of.817 818 Waltham, School Commissioners of.818 Sales by Licitation: 821 Chamberland vs Charbonncau et al.821 SHERIFFS' SALES: Bedford: 822 Tétrcault vs Dufort.S22 Chicoutimi: 822 Côté Boivin Auto Service Inc.vs Lavoie 822 Joliette: 823 Armstrong vs Armstrong.823 The Quebec Farm Loan Board vs 823 Desrochers.823 Kamouraska: 824 Parish of St-Benoît Abbé, vs Ducas.824 824 Parish of St-Benoît Abbé vs Thériault.824 Montreal: 825 Saintonge vs Taillefcr.825 Quebec: The Quebec Farm Loan Board vs 826 Salvas.826 Traders Finance Corporation Limited 825 vs Thibault.825 Rimouski: 826 Joubert et al vs Labric.826 Roberval: 827 Pronovost & Frères Enrg.vs Lambert.827 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March Oth, 1954, Vol.80, No.10 831 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rëdempti Paradis imprimeur de la Reine.Queen's Printer.Saguenay: Saguenay: Imbault vs Tremblay.827 Imbault vs Tremblay.827 3073S-o 36738-o "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.