Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 5 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1954-06-05, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 86, N- 23 1785 Vol.86, No.23 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 5 juin 1954 ./ Quebec, Saturday, June 5th, 1954 AVIS AUX INTÉRESSÉS NOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements Rules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The Queen's meur de la Reine, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine will be suspended without further notice and qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute without prejudice as regards the rights of the somme versée en plus.Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank mandat de banque ou martdat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for.Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1780 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 1954, Tome 86, N* 28 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise, if*'-.Tarif des Annonces, Abonnements, etc* Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.36322\u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so *>sio avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per ear.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our tcans-lation.Notice published but once are followed oaly by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.36322 \u2014 1-52 Lettres patentes Letters Patent (P.G.10874-54) Alma Jobbing Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1954, constituant en corporation: Adrien Harvey, marchand, Noëlla Savard Harvey, ménagère, épouse contractuellcment séparée de biens dudit Adrien Harvey, et Roland Bouchard, commis, tous de Saint-Joseph d'Alma, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer le commerce de lingerie, de marchandises sèches, de denrées alimentaires, de quincaillerie, d'ustensiles de cuisine, sous le nom de \"Alma Jobbing Limitée\", avec un capital total de $49,000, divisé en 4,900 actions de §10 chacune.Le siège social de :a compagnie sera à 177, rue St-Joseph, Saint-Joseph d'Alma, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-0 P.FRENETTE.(A.G.10874-54) Alma Jobbing Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May 1954, incorporating: Adrien Harvey, merchant, Noëlla Savard Harvey, housewife, wife contractually separated as to property of the said Adrien Harvey, and Roland Harvey, clerk, all of Saint Joseph d'Alma, judicial district of Roberval, for the following purposes: To deal in lingerie, dry goods, foodstuffs, hardware, kitchen ustensils, under the name of \"Alma Jobbing Limitée\", with a total capital stock of $49,000, divided into 4,900 shares of $10 each.The head office of the company will be at 177 St.Joseph Street, Sairt Joseph d'Alma, judicial district of Roberval.Dated at the office of-the Attorney General, this seventh day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 6th, 1954, Vol.86, No.S3 1787 (P.G.11186-54) Charles Gravel Ltdc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1954, constituant en corporation : Jean Joseph Potvin, Lorenzo Brisson, tous deux commerçants, et Charles Gravel, rentier, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements, lingerie, articles de maison, quincaillerie, bibelots, objets d'art, accessoires électricpies et articles de toilette, sous le nom de \"Charles Gravel Ltéc\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 270, rue Roussel, Sainte-Anne-de-Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-0 P.FRENEÏTE.(P.G.11253-54) Constantin Autos Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1954, constituant en corporation: Jean-Pierre Constantin, garagiste, Thérèse Constantin Gagné, marchande publique, épouse contractucllement séparée de biens de Jèan-Paul Gagné, et Jean-Paul Gagné, contrôleur de trains, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagiste et excrcei* le commerce d'automobiles, sous le nom de \"Constantin Autos\" Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 700 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la Ville de Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le quatorze mai 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(A.G.11186-54) Charles Gravel Lté*e Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May 1954, incorporating: Jean Joseph Potvin, Lorenzo Brisson, both merchants, and Charles Gravel, annuitant, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, lingerie, household furnishings, hardware, knick-knacks, works of art, electrical appliances and toilet requisites, under the name of \"Charles Gravel Ltée\", with a total capital of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 270 Roussel Street, Sainte Anne de Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10861-54) Diehl Publication Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1954, constituant en corporation: Maurice Mercier, avocat, Thérèse Servant et Fernande Boisvert, toutes deux sténographes, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, lithographes et graveurs, sous le nom de \"Diehl Publication Incorporated\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominal.Le siège social de la compagnie sera à Mont-» réal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le onze mai 1954.L'Assistant-procureur général, suppléant, 37314-0 P.FRENETTE.(A.G.11253-54) Constantin Autos Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth of May 1954, incorporating: Jean-Pierre Constantin, garage keeper, Thérèse Constantin Gagné public merchant wife contractually separate as to property from Jean-Paul Gagné, and Jean Paul Gagné, train conductor all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage keeper and to deal in automobiles under the name of \"Constantin Autos Inc.\", with a capital of $100,000 divided into 300 common shares of $100 each and into 700 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be in the town of St-Eustache, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth of May 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.G.10861-54) Diehl Publication Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May 1954, incorporating: Maurice Mercier, advocate, Thérèse Servant and Fernande Boisvert, both stenographers, filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as printers, lithographers and engravers, under the name of \"Diehl Publication Incorporated\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General. 1788 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 195/,, Tome 86, N° 23 (P.G.11145-54) Gcutilly Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de-Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1954, constituant, en corporation: Irwin A.Frankel, Louis Benjamin, tous deux avocats, et Sadie Gcrsovitz, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de .Montréal, pour les objets suivants: v Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"(ientilly Holdings Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 400 actions privilégiées do S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le premier mai 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(P.G.10934-54) Gordon-Lacey Chemical Products.Company, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix mai 1954, constituant en corporation: Louis Pitch, c.r., de West mount.Solomon Weber, c.r.d'Outreniont, et Nathan Abraham Levitsky.de Montréal, tous avocats, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de produits chimiques, sous le nom de \"Gordon-Lacey Chemical Products Company.Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-e P.FRENETTE.(P.G.11123-54) Hamel Transport Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre mai 1954, constituant en corporation: Emile Hamel, Alfred Hamel et Paul Hamel.tous camionners, de .Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer les entreprises d'une compagnie de transport, sous le nom de \"Hamel Transport Ltd\", avec un capital total de $60,000, divisé en 600 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie à Clubouga-mau, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le quatre mai 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(P.G.11274-54) Hudson Investment Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date (A.G.11145-54) Gcutilly Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first of May 1954.incorporating: Irwin A.Frankel, Louis Benjamin, both advocates, and Sadie Gersovitz, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business of real estate, under the name of \"(Ientilly Holdings Inc.\".with a capital stock of 850,000, divided into 100 common shares of 8100 each and into 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first of May 1954\".L.DÉSILETS, 37311 Deputy Attorney General.(A.G.10934-54) Gordon-Laccy Chemical Products, Company, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of May 1954, incorporating: Louis Fitch.Q.C., of Westmount, Solomon Weber, Q.C., of Outre-inont.and Nathan Abraham Levitsky, of Montreal, all advocates, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in chemical products, under the name of \"Gordon-Lacey Chemical Products Company, Ltd.\", with a total capital stock of $20.000.divided into 200 common shares *>f 8100 each.The head office of the company will be at .Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11123-54) Hamel Transport Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of May 1954.incorporating: Emile Hamel, Alfred Hamel and Paul Hamel.all truckers, of St-Félicien, judicial district of Roberval, for the following purposes: To carry on the business of a transport company, under the name of \"Ilamel Transport Ltd\", with a capital stock of $60,000 divided into 600 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Chibougamau, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of May 1951.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.(L 11274-54) Hudson Investment Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, J95/,, Vol.80, No.23 1789 du huit mai 1954, constituant en corporation: Gaston Pquliot, avocat, Andrée Bourdon, sténographe, fille majeure, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, et Richard La-fontaine, avocat, de Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Hudson Investment Ltd\", avec un capital total de $20,009, divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procurçur général le huit mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-0 P.FRENETTE.(P.G.10852-54) Laurcnlian Brick Company Limited La Compagnie Laurcnticmics de Briques Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1951-, constituant en corporation: Luc Geoffroy, André Qucsnel, tous deux avocats, et Yves Masson, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de briques, tuiles, ciment, pierre, bois, matières plastiques, verrerie et sous-produits, sous le nom de \"Laurentian Brick Company Limited\" \u2014 \"La Compagnie Laurentienne de Briques Limitée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Antoine-des-Laurcntides, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau-du Procureur général le neuf avril 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-o P.FRENETTE.(P.G.11080-54) L.D.Serres Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1954, constituant en corporation: Louis-Denis Serres, bourgeois, Maria Lachaine,.épouse contractuellcment séparée de biens dudit Louis-Denis Serres, et Charles-Edouard Champagne, constructeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et de matériaux de construction et.agir comme entrepreneur général en construction, soiis le nom de \"L.D.Serres Compagnie Limitée\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions de .8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le onze mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-o P.FRENETTE.(P.G.11169-54) Les Pavages de Beauce Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a of May 1954, incorporating: Gaston Pouliot, advocate, Andrée Bourdon, stenographer, fille majeure, both of the city and judicial district of Montreal, and Richard Lafontaine, advocate, of Yalleyfiled, judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"Hudson Investment Ltd\", with a total capital stock of 820,000, divided into 10,000 common shares of a par value of SI each and 2,000 preferred shares of a par value of So each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at (be office of the Attorney General, this eighth day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10852-54) Laurentian Brick Company Limited La Compagnie Laurcnlicnncs de Briques Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April 1954, incorporating: Luc Geoffroy, André Quesnel, both advocates, and Yves Masson, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in bricks, tiles, cement, stone, lumber, plastic substances, glassware and by-products, under the name of \"Laurentian Brick Company Limited\" \u2014 \"La Compagnie Laurentienne de Briques Limitée\", with a total capital slock of 840,000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company will be at Saint-Antoinc-dcs-Laurentides, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11080-54) L.D.Serres Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May 1954, incorporating: Louis Denis Serres, gentleman, Maria Lachaine, wife contractually separated as to property of the said Louis Denis Serres, and Charles Edouard Champagne, builder, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate and building materials and act as a general building contractor, under the name of \"L.D.Serres Compagnie Limitée\", with a total capital stock of S 100,000, divided into 1,000 shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11169-54) Les Pavages de Beauce Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1790 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1954, Tome 86, N° S3 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1954, constituant en corporation: Paul-Eugène Busqué, Hervé Poulin, tous deux entrepreneurs, de Beaucevillc-Oucst, et Gérard Poulin, épicier licencié, de Bcauceville-Est, tous du district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs pour l'exécution de travaux de pavage et de construction de tous genres, sous le nom de \"Les Pavages de Beauce Limitée\", avec tin capital total de $40,000, divisé en 4.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Bcauce-ville-Ouest, district de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-0 P.FRENETTE.(P.G.11049-54) P.E.Lortic Limitée P.E.Loi i ie Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sent mai 1954, constituant en corporation: Paul-Ëmile Lortie, marchand, Dame Êva Côté, Lortic, ménagère, épouse séparée de biens dudit Paul-Éiriile Lortie et Thérèse Lortic, ménagère, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles et accessoires nécessaires pour meubler une maison, sous le nom de \"P.E.Lortie Limitée\"\u2014\"P.E.Lortie Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8211, rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le sept mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-o P.FRENETTE.(P.G.10994-54) St.Lambert Lumber & Builders Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze avril 1954, constituant en corporation: Paul Bégin, vérificateur, Gactane Richer, sténographe, et Annette Lacroix, employée civile, ces deux dernières filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et exercer le commerce du bois, des huiles, de métal et de ciment et faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"St.Lambert Lumber & Builders Supplies Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le douze avril 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-0 P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, bearing date the seventh day of May, 1954, incorporating: Paul Eugène Busqué, Hervé Poulin, both contractors, of Beauccville-West, and Gérard Poulin, licensed grocer, of Beauce-ville-East, all of the judicial district of Beauce, for the following purposes: To carry on business as contractors and carry out pavement and construction work of every nature and kind, under the name of \"Les Pavages de Beauce Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into, 4000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Beauccville-West, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11049-54) P.E.Lortie Limitée P.E.Lortic Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1954 incorporating: Paul Emile Lortie, merchant, Mrs.Eva Côté Lortic, housewife, wife separate as to property of said Paul Emile Lortie, and Thérèse Lortie, housekeeper, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in furniture and household furnishings, under the name of \"P.E.Lortie Limitée\"-\"?.E.Lortie Limited\", with a, total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.* The head office of the company will be at 8211 St.Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10994-54) St.Lambert Lumber & Builders t- , Supplies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of April 1954, incorporating: Paul Begin, auditor, Gaëtane Richer, stenographer, and Annette Lacroix, civil servant, the two latter filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in lumber, oils, metal and cement, and carry on business as general contractors, under the name of \"St.Lambert & Builders Supplies Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of April, 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, 195/,, Vol.86, No.S3 1791 (P.G.11173-54) Torino Furniture Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix mai 1954, constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de Wcstmount, Sydney Phillips, avocat, et Murray Bernard Spiegel, étudiant en croit, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et exercer le commerce de meubles, d'instruments de musique, de marchandises sèches, de vêtements, sous le nom de \"Torino Furniture Ltd.\", avec un capital total de §20,000, divisé en 50 actions ordinaires de S100 chacune et en 150 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix mai 1954.L'Assistant-procureur général suppléant, 37314-0 P.FRENETTE.Lettres patentes annulées (A.G.11173-54)^ Torino Furniture Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of May 1954, incorporating: John J.Wasserman, advocate, of Westmount, Sydney Phillips, advocate, and Murray Bernard Spiegel, law student, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, musical instruments, dry goods, wearing apparel, under the name of \"Torino Furniture Ltd.\", with a total capital stock of S20.000, divided into 50 common shares of S100 each and 150 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May 1954.P.FRENETTE, 37314 Acting Deputy Attorney General.Letters Patent Annuled .it Avis est donné qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 537, en date du 28 mai 1954, adopté sous l'autorité des dispositions de l'article 25a de la Loi des compagnies de Québec, S.R.Q.1941, chapitre 276, telles qu'ajoutées par la loi 10 George VI, chapitre 48, l'annulation des lettres patentes des compagnies ci-après mentionnées a été décrétée, à savoir: Nom de la compagnie: ¦ Constituée le: Name of Companies: Incorporated: The Brokerage Corporation, Limited.22 octobre 1920.(of Canada) October 22, 1920.Club Night Cap Incorporé.15 mars 1938.March 15, 1938.Dorchester Realty Company Limited.16 juillet 1929.July 16, 1929.Échange National Limitée.10 mai 1950.May 10, 1950.Léonard Fisheries Limited.22 novembre 1933.November 22, 1933.Mount Royal Lingerie Inc.25 octobre 1947.October 25, 1947.O'Connor's Fish Company Limited.18 décembre 1932 .December 18, 1932.Service Social and Bridge Club Inc.25 mai 1937.May 25, 1937.Notice is hereby given that in accordance with Order In Council number 537, dated May 28, 1954, adopted under the authority of provisions section 25a of the Quebec Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 276, such as added thereto by Act 10 George VI, chapter 48, the annulment of Letters Patent of the companies hereinafter mentioned has been enacted, to wit: Siège social: Head Office: Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Québec.Quebec.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.37314-0 Le Procureur général de la province de québec, parL.DÉSILETS, Assistant-procureur général.37314 The Attorney general, of the Province of Quebec, per L.DÉSILETS, Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens Actions for separation as to property Cour supérieure, district d'Arthabaska, N° 9387.Dame Eva Carrignan, épouse de Éloi Marcotte, journalier de St-Simon de Drummond, district d'Arthabaska, a formé contre son mari une action en séparation de biens.Drummondville, le 29 mai 1954.Le Procureur de la demanderesse, 37331-0 PAUL ROUSSEAU, C.R.Superior Court, district of Arthabaska, No.9387.Dame Eva Carignan, wife of Éloi Marcotte, labourer of St-Simon de Drummond, district of Arthabaska, has taken action against her husband in separation as to property.Drummond May 29th 1954.PAUL ROUSSEAU, Q.C., 37331-0 Attorney for the plaintiff. 1792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 1954, Tome 86, N° 23 Canada, Province de Québec, District de Hull, dans la Cour Supérieure, N° 2974.Daine Marie Price, épouse commune en biens de Wilson Parolier, plombier-retiré, tous doux de la Ville de Buckingham, district de Hull, et dûment autorisée aux présentes par jugement do cette Cour, demanderesse, vs ledit Wilson Parolier, défendeur.AVIS Une action en séparation de biens a été instituée on cette cause.Hull, oc 31 mai 1954.Le Procureur do la demanderesse, 37332-0 (signé) ARTHUR LABBÉ,C.R.Avis divers LA BoULAXGEME NATIONALE Ll.uitée Règlemen spécial \"F\" Un règlement pour autoriser la distribution de l'actif de la compagnie.L'actif de la compagnie sera distribué au prorata entre ses actionnaires suivant leurs droits respectifs ou conformément aux directives de distribution données à la compagnie par tous les actionnaires.Vraie copie certifiée du règlement spécial \"F\" décrété par les directeurs le 2 novembre 1951 et dûment approuvé et sanctionné à une assemblée générale spéciale dûment tenue le 2 novembre 1951.Daté à Montréal, ce 17e jour de mai 1954.Le Secrétaire, 37317 (Signé) J.W.TAIT.(P.O.7945-49) Avis est, par les présentes, donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province, a approuvé le 21 mai 1954.les règlements de \"Negro Community Centre\", et ce, conformé-mont aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 25e jour de mai 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 37318 JEAN BRUCHÉSI.(P.O.12547-52) QUEBECAIR LnC Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de \"Quebecair Inc.', dûment convoqué et tenue à Rimouski, le 29 avril 1954: \"Proposé par monsieur Wilfrid Ouellet, secondé par monsieur Henri Jacob et résolu unanimement d'amender les règlements généraux - de la Compagnie, comme suit : a) Réduire le nombre dos directeurs de 8 à 5; b) Réduire le quorum des directeurs à 3; c) Changer l'adresse du siège social de la Compagnie pour l'établir à 76, Avenue de la Cathédrale, dans la ville de Rimouski.\" Certifiée vrai copie.Le Vice-président & secrétaire, 37319-0 MAURICE TESSIER.Canada, Province of Quebec, District of Hull, in the Superior Court, No.2974.Dame Marie Price, wife common as to property of Wilson Parolier, retired-plumber, district of Hull, and duly authorized by this court, plaintiff, vs the said Wilson Parchor, defendant.NOTICE An action in separation as to property has been instituted in this case.Hull, May 31st 1954.(Signed) ARTHUR LABBÉ, Q.C.37332-o Attorney for the plaintiff.Miscellaneous Notices La Boulangerie Nationale Limitée Special By-law \"F\" A by-law to authorize the distribution of the Company's assets.The assets of the Company shall be distributed ratoably amongst its Shareholders in accordance with their respective rights or in accordance with the directions for distribution given to the Company by all the Shareholders.Certified true copy of Special By-law \"F\" enacted by the directors on November 2, 1951 and duly approved and sanctioned at a Special General Meeting duly held on November 2, 1951.Dated at Montreal, this 17th day of May, 1954.(Sgd.) J.W.TAIT, 37317-0 Secretary.(A.G.7945-49) Notice is hereby given that, upon the recom-dation of the Deputy Attorney General, the By-laws of \"Negro Community Centre\" were approved on May 21st, 1954, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary this 25th day of May, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 37318-0 Under-Secretary of the Province.(A.G.12547-52) Quebecair Inc.Excerpt from minutes of an annual general meeting of shareholders of \"Quebecair Inc.\", duly called and held at Rimouski, April 29, 1954: \"Proposed by Mr.Wilfrid Ouellet, seconded by Mr.Henri Jacob and unanimously resolved that the general by-laws of the Company be amended as follows : a) Decrease the number of directors from 8 to 5; b) Decrease the quorum of directors to 3.c) Change the address of the Company's head office in order that it be located at 76 de la Cathédrale Avenue, in the Town of Rimouski.\" Certified true compv.MAURICE TESSIER, 37319 Vice-President & Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, 195J,, Vol.86, No.23 1793 AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le quinze mai 1954, le changement de nom de ^'Association Catholique des Institutrices Laïques de Saint-Hyacinthe\", dont la constitution en syndicat professionnel, sous le nom originaire de \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 18\", avec siège social à Saint-Hyacinthe, a été autorisée le 28avr.'l 1944.en celui de \"Syndicat des Instituteurs de Belœil\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels, (S.R.Q.1941, chapitre 102).Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce dix-huit mai 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 37320-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association «les Éleveurs de Poulets de Gril du Québec\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le dix-neuf mai 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Québec, dans le district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la Parovince, 37321-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.10222-52) United Metals & Petroleum Corporation (No Personal Liability) Règlement N° 6 Règlement changeant le nombre des directeurs.Qu'il soit décrété et il est par les présentes, décrété comme le règlement N° 6 «le \"United Metals & Petroleum Corporation\" (N.P.L.) (ci-après appelée \"la compagnie\") ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de cinq (5) à trois (3).2° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Décrété ce 15e jour de février 1954.(Sceau) Le Président, Y.GALLET née BROUSSE.Le Secrétaire-trésorier, 37334 GISÈLE BEHOCARAY.(P.G.49044-53) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le vingt-huit mai 1954, les amendements apportés aux articles 25 et 31 (31 A) des règlements de \"L'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi\", tels qu'adoptés à l'assemblée générale spéciale tenue le 2 mars 1954, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le trente et un mai 1954.Le Sous-secrétaire de la province, 37335-0 JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicales' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized on May fifteenth, 1954.the change of name of the \"Association Catholique des Instituteurs Laïques «le Saint-Hyacinthe\", whose incorporation into a professional syndicate, under the original name of \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District No.18\", with head office at Saint-Hyacinthe, was authorized on April 28, 1944.into that of \"Syndicat «les Instituteurs de Belœil\", and such, pursuant to the provisions of sections 7 and following of the Professional Syndicates' Act (R.S.Q.1911, chapter 102).Given at the office of the Provincial Secretary this eighteenth day of May, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 37320 Under Secratary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act).The formation of an association under the name of \"Association des Éleveurs de Poulets de Gril du Québec\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May nineteenth 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Quebec, in the judi-district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 37321 Under Secretary of the Province.(A.G.10222-52) United Metals & Petroleum Corporation (No Personal Liability) By-law No.6 By-law changing number of Directors.Be it enacted and it is hereby enacted as Bylaw No.6 of \"United Metals & Petroleum Corporation\" (N.P.L.) (hereinafter called \"the Company\") as follows: 1.The number of the board of directors of the Company be and it is hereby decreased from five (5) to thrce(3).2.The By-laws of the Company be and they are hereby amended to accord with the foregoing.Enacted this 15th dav of February, 1954.(Seal) Y.GALLET née BROUSSE, Piesident.GISÈLE BEHOCARAY.37334-o Sccretary-Trea.su rer.(A.G.49044-53) Notice is hereby given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved, on May twenty-eighth 1954, the amendments to article 25 and 31 (31 A) of the By-laws of \"L'Oeuvre Pontificale de la Propagation «le la Foi\", such as they were adopted at a special general meeting held on March 2, 1954, and thus, pursuant to the provisions of Section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the thirty-first day of Mav 1954.JEAN BRUCHÉSI, 37335 Under Secretary of the Province. 1794 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 195/,, Tome 86, N° 28 AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association des Constructeurs de la région Lac Saint Jcan-Roberval\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le trente et un mai 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Joseph d'Alma, dans le comté du Lac St-Jean.Le Sous-secrétaire de la Province, 3733S-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association des Constructeurs de la Région Lac Saint Jean-Roberval\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May thirty-first 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint Joseph d'Alma, in the County of Lake St.John.JEAN BRUCHÉSI, 37338 Under Secretary of tiie Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Association Professionnelle des Employés de \"Biscuits Dion Inc.\" (Inc.)\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-six mai 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Québec, dans le district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la Province, 37339-û JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Association Professionnelle des Employés de \"Biscuits Dion Inc.\" (Inc.) for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on May twenty-sixth 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Québec, in the judicial district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 37339 Under Secretary of the Province.(P.G.13532-53) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province, a, le 25e jour de mai 1954, approuvé le règlement trois de \"Hillsdale Golf and Country Club Inc.\" tel qu'adopté à l'assemblée tenue le 1er mars 1954, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce premier jour de juin 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 37353 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.5162-43) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province, a, le 28e jour de mai 1954, approuvé les règlements 1 à VII de \"Federation of English Speaking Catholic Teachers Inc.\", tels qu'adoptés à une assemblée tenue le 24 mars 1954, et ce conformément aux aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce premier jour de juin 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 37354 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.10950-52) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le trente et un mai 1954, les règlements de \"L'Association des Dames Patronesses de l'Hôpital Sanatorium St-Joseph Incorporée\", tels qu'adoptés à l'assemblée générale tenue le 23 septembre 1952, et modifiés à l'assemblée générale du 6 avril 1954, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.(A.G.13532-53) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-Law Three of \"Hillsdale Golf and Country Club Inc.\", as adopted at the meeting held on March 1st, 1954, was approved by the Honourable the Provincial Secretary on the 25th day of May, 1954, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Compagnies Act.Given at the office of the Provincial Secretary this first day of June, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 37353-0 ' Under-Secretary of the Province.(A.G.5162-43) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-Laws 1 to VII of the \"Federation of English Speaking Catholic Teachers Inc.\", as adopted at the meeting held on March 24th, 1954, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on the 28th day of May, 1954, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Compagnies Act.Given at the office of the Provincial Secretary this first day of June, 1954.^ JEAN BRUCHÉSI, 37354-0 Under-Secretary of the Province.(A.G.10950-52) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved, on May thirty-first 1954, the by-laws of \"L'Association des Dames Patronesses de l'Hôpital Sanatorium St-Joseph Incorporée\", such as they were adopted at a general meeting held September 23, 1952, and amended at a general meeting on April 6, 1954, and thus, pursuant to the provisions of Section 225 of the Quebec Companies' Act. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, 195/+, Vol.86, No.23 1795 Donné au bureau du Secrétaire de la province le premier juin 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 37355-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.11254-54) Radio Accessoiues Limited Règlement N° 25 Un règlement qui augmente le nombre des directeurs de \"Radio Accessories Limited\".Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Radio Accessories Limited\" (ci-après nommée la compagnie), ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de \"Radio Accessories Limited\" soit, et il est, par les présentes, augmenté de trois (3) à quatre (4), de manière que le bureau de direction de \"Radio Accessories Limited\" soit composé dorénavant de quatre directeurs (4).2° Que trois (3) directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Que tous les règlements, résolutions et procédures de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.Passé ce 27e jour d'avril 1954.Témoin : Le sceau corporatif de la compagnie.Le Président, B.MANIS.Le Secrétaire, 37365 DAVID M.NOTKIN.(P.G.4705-46) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le vingt-six mai 1954, les règlements généraux (A) du \"Service de Réadaptation Sociale Inc.\", tels qu'adop tés à l'assemblée 'générale annuelle tenue le 31 mars 1954,'et ce, conformément aux dispositions de l'article [225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le trente et un mai 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 37368-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.11057-54) Dickson & Dumais Co.Ltd.\"Sur motion de J.Alfred Savoie appuyé par Jean-Paul Croteau, il est résolu que le paragraphe 1 du règlement N° 3 de la compagnie soit amendé en remplaçant les mots \"cinq directeurs\" par les mots \"neuf directeurs\" ainsi que le paragraphe 14 du règlement N° 3 de ladite compagnie soit amendé en remplaçant les mots \"trois\" par \"cinq\" et après que ladite résolution aura été confirmée par les actionnaires, qu'une copie soit transmise au secrétaire de la Province pour être publiée dans la Gazette Officielle de Québec pour avoir effet aussitôt après la parution dans ladite Gazette Officielle et les-dits nouveaux directeurs devant être nommés par une assemblée des directeurs déjà en fonction.\" Vraie copie.Le Secrétaire, 37371-0 NORMAND PROVENCIIER.Given at the office of the Provincial Secretary the first day of June 1954.JEAN BRUCHÉSI, 37355 Under Secretary of the Province.(A.G.11254-54) Radio Accessories Limited By-law No.25 A By-law for increasing the number of Directors of \"Radio Accessories Limited\".Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"Radio Accessories Limited\" (hereinafter oalled the Company) as follows: 1.The number of directors of \"Radio Accessories Limited\" be and the same is hereby increased from three (3) to four (4), so that the Board of Directors of \"Radio Accessories Limited\" shall hereafter be composed of four (4) directors.2.That three (3) directors shall constitute a quorum of any Meeting of the Board of Directors.3.That all By-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this By-law.Passed this 27th day of April, 1954.Witness the corporate seal of the Company.B.MANIS, President.DAVID M.NOTKIN, 37365-0 Secretary.(A.G.4705-46) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable Provincial Secretary approved, on May twenty-sixth 1954, general by-laws (A) of the \"Service de Réadaptation Sociale Inc.\", such as they were adopted at a annual general meeting held on March thirty-first 1954, and thus, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, May thirty-first 1954.JEAN BRUCHÉSI, 37368 Under Secretary of the Province.(A.G.11057-54) Dickson & Dumais Co.Ltd.\"On motion by J.Alfred Savoie seconded by Jean Paul Croteau, it is resolved that paragraphe 1 of the Company's By-law No.3 shall be amended by replacing the words \"five directors\" by those of \"nine directors\", as well as paragraph 14 of said Company's By-law No.3 be amended the word \"three\" by that of \"five\", and after confirmation therof by the shareholders, that a copy be forwarded to the Provincial Secretary for publication in the Quebec Official Gazette, to take effect immediately after appearing in said Official Gazette, and the said new directors to be appointed by a meeting of directors already in office.\" True Copy NORMAND PROVENCHER, 37371 Secretary. 1796 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 195/,, Tome 86, N° 23 Chartes \u2014 Abandon de AVIS De demande d'abandon de charte Avis est par les présentes donné que \"North-wood Apartments Inc.\", nue corporation établie sous la Loi des Compagnies du Québec, s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de la Province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies de Québec, ladite corporation a cessé de l'aire affaires depuis le 30 avril, 1954.Daté à Montréal, le 2S jour de mai.1954.Les Procureurs pour Xorlhwood.Apartments Inc., Mtres.CRESTOIIL & CRESTOHL.1010 St.Catherine Street West, Montréal, Québec.37323-0 Marché Su a wink; an Market Ltée Avis d'appication pour permission d'abandonner la charte Avis est par les présentes donné que \"Marché Shawinigan Market Ltée.\" qui a son bureau principal dans la cité de Shawinigan Palis, Province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies de Québec.Montreal, P.Q., ce 19 mai 1954.Marché Shawinigan Market Ltée, Par le Secrétaire, 37324-o GÉRARD CLERMONT.AVIS De demande d'abandon de charte Avis est par les présentes donné que \"Beverley Apartments Inc.\", une corporation établie sous la Loi des Compagnies de Québec, s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de la Province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies du Québec, ladite corporation a cessé de faire affaires depuis le 30 avril, 1954.Daté à Montréal, le 28 jou.i de mai, 1951.Les Procureurs pour Beverley Apartments Inc.Mtres.CRESTOIIL & CRESTOIIL.1010 St.Catherine Street West, Montréal, Québec.37322-0 Charters \u2014 Surrender of NOTICE Application for surrender of charter \"Northwood Apartments Inc.\", of the City and District of Montreal, incorporated under letters patent of the Province of Quebec, hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec for leave to surrender the Charter of the Company, under the provisions of the Quebec Companies' Act.the said Company having ceased to carry on business as of April 30th, 1954.Dated at Montreal, this 28th day of May, 1954.Messrs.CRESTOIIL & CRESTOHL, Solicitors for Nortwood Apartments Inc.1010 St.Catherine Street West, Montreal, Quebec.37323-0 Marché Shawinigan Market Ltée Notice of application for, leave to surrender charter Notice is hereby given that \"Marché Shawinigan Market Ltée\", which has its head office in the City of Shwinigan Palls, in the Province of Quebec, will make application for leave to surrender its Charter in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, P.Q., May 19th, 1954.Marché Shawinigan Market Ltée, per: GÉRARD CLERMONT, 37324-0 Secretary.NOTICE ' Application for surrender of charter \"Beverley Apartments Inc.\", of the City and District of Montreal, incorporated under letters patent of the Province of Quebec, hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec for leave to surrender the Charier of \"the Company, under the provisions of the Quebec Companies' Act, the said Company having ceased to carry on business as of April 30th, 1954.Dated at Montreal, this 28th day of May, 1954.Mcsrrs.CRESTOHL & CRESTOHL, Solicitors for Beverley Apartments Inc.1010 St.Catherine Street West, Montreal, Quebec.37322-0 Compagnies dissoutes (P.G.S403-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"American Javel Water Company Limited\" \u2014 \"Eau de Javelle Américaine Compagnie Limi- Companies Dissolved (A.G.8403-52) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"American Javel Water Company Limited\" \u2014-\"Eau de Javelle Américaine Compagnie Limi- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, June 5th, lf)5J{, Vol.86, No.23 1797 tée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 février 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général.37314-0 L.DÉSILETS.(P.G.10100-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts Refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Gracofield Lumber Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 juin 1934,.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(P.G.49521-53) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276.article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Marlene Dress Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 novembre 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-o , L.DÉSILETS.(P.G.10842-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"New Jersey Zinc Explorations Limited\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 12 mai 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procuieur général, 37314-0 L.DÉSILETS, (P.C.10517-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Riverside Manufacturing Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 novembre 1934.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.tée\", incorporated by letters patent dated February 11, 1944.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.G.10100-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Gracefield Lumber Company Limited\", incorporated by letters patent dated June 14, 1934.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37311 Deputy Attorney General.(A.G.49521-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Marlene Dress Incorporated\", incorporated by letters patent dated November 2nd, 1944.Notice is also given .that from and after June 1st.1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS.37314 Deputy Attorney General.(A.G.10842-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"New Jersey Zinc Explorations Limited\", incorporated under the Quebec Mining Companies' Act by letters patent dated May 12, 1948.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.G.10517-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Riverside Manufacturing Company Limited\", incorporated by letters patent dated November 28, 1934.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General. 1798 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1954, Tome 86, N° S3 (P.G.10975-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Standard Equities Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 mars 1932.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-o L.DÉSILETS.(P.G.10769-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"St.Lawrence Homes Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 29 avril 1943- Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(P.G.10377-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"The Lcbolf Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 août 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(P.G.10470-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Trans-Continental Tourist Information Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 avril 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le deux juin 1954.L'Assistant-procureur général, 37314-0 L.DÉSILETS.(A.G.10975-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Standard Equities Limited\", incorporated by letters patent dated March 8, 1932.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd.1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.G.10769-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"St.Lawrence Homes Limited\", incorporated by letters patent dated April 29, 1943.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.G.10377-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"The Leboff Corporation\", incorporated by letters patent dated August 20, 1948.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.(A.G.10470-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Trans-Continental Tourist Information Limited\", incorporated by letters patent dated April 4, 1949.Notice is also given that from and after June 1st, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June 2nd, 1954.L.DÉSILETS, 37314 Deputy Attorney General.Département de l'Agriculture Avis est donné, par les présentes, que le ministre de l'Agriculture a autorisé la formation d'un cercle agricole dans le comté d'Abitibi- Department of Agriculture Notice is hereby given, that the Honourable the Minister of Agriculture has authorized the formation of a Farmer's Club in the County QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, 1954, Vol.86, No.28 1799 Ouest, sous le nom de cercle agricole de la pa- of Abitibi-West, under the name of Farmers' roisse de St-Émile de Guyenne, conformément Clubs Act, (R.S.Q.1941, Chap.118).à la Loj des cercles agricoles, (S.R.Q.1941, Chap.118).Dated at the Minister's office, May 25th, Daté du bureau du ministre, le 25 mai 1954.1954.Le Sous-ministre de l'Agriculture, RENE TREPANIER, 37361-0 RENÉ TREPANIER.37361 Deputy Minister of Agriculture.Avis est donné, par les présentes, que le ministre de l'Agriculture a autorisé la formation d'un cercle agricole dans le comté d'Abitibi-Ouest, sous le nom de cercle agricole de la paroisse de St-Laurent de Gallicham, conformément à la Loi des cercles agricoles, (S.R.Q.1941 Chap.118).Daté du bureau du ministre, le 25 mai 1954.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 37361-o RENÉ TREPANIER.Notice is hereby given, that the Honourable the Minister of Agriculture has authorized the formation of a Farmers' Club in the County of Abitibi-West, under the name of Farmers' Club of the Parish of St.Laurent de Gallichan, pursuant to the Farmers' Clubs Act, (R.S.Q.1941, Chap.118).Dated at the Minister's office, May 25th, 1954.RENÉ TREPANIER, 37361 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 1-61B Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mardi, 25 mai 1954, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal, à 10 heures de l'avant-midi.Présents: MM.Orner E.Milot, président, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-Albert Chartrand, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire et C.A.Gamache, C.R'., aviseur légal.Attendu que la Commission de l'Industrie Laitière doit fixer le prix du lait, en tenant compte de la valeur du produit, des conditions de sa production, de sa manipulation, de sa livraison et des conditions des divers marchés locaux, de façon à sauvegarder les intérêts des fournisseurs-producteurs, des marchands de lait, des distributeurs de produits laitiers et des consommateurs ; Après avoir considéré les conditions de l'industrie laitière dans la région de Montréal; La Commsiion décrète ce qui suit: 1° L'ordonnance N° 1-51, publiée dans la Gazette officielle de Québec le 6 octobre 1951, est modifiée en remplaçant le paragraphe 3 par le suivant: \"3° Les marchands de lait, les sociétés coopératives et les syndicats coopératifs doivent payer à leurs fourniaBeurs-producteurs, pour chaque cent livres de lait dosant au moins 3.5% de matières grasses qu'ils reçoivent de ceux-ci $4.40 F.A.B.Montréal, et à même cette somme, payer à la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec, un demi-cent par cent livres de lait ainsi reçu.Le paiement aux fournisseurs-producteurs se fera sur une base de 3.5% de matières grasses: a) plus une prime de trois cents par cent livres de lait, pour chaque dixième de 1% au-dessus de ce pourcentage; b) moins un rabais de trois cents par cent livres de lait pour chaque dixième de 1% au-dessous de ce pourcentage.\" Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.1-51B Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Tuesday, May 25th, 1954, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs, Omer E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.Albert Chartrand, commissioners, Alphonse Savoie, Secretary and C.A.Gamache, Q.C., Legal Adviser.Whereas the Dairy Industry Commission must set the price of milk by taking into account the value of the product, the conditions under which it is produced, its handling, its delivery and the conditions of the various local markets, in order to protect the interests of the producers-suppliers, the milk dealers, ffie distributors of dairy products, and the consumers; Considering the condition of the dairy industry within the region of Montreal; It is enacted as follows: 1.Order No.1-51 published in the Quebec Official Gazette, October 6th, 1951, is modified by replacing paragraph 3 by the following: \"3.Milk dealers, cooperative societies and cooperative syndicates must pay to their producers supplies for each hundred pounds of milk on a 3.5% butter fat bassis or more which they receive from them, S4.40 F.O.B.Montreal and out of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec, one-half cent for each hundred pounds of milk received.The payment of milk shall be made on a basis of 3.5% butterfat: a) À premium of three cents per hundred pounds of milk shall be added for each tenth of 1% over this percentage; b) A deduction of three cents per hundred pounds of milk shall be made for each tenth of 1% below this percentage.\" 1800 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 juin 1964, Tome 86, N° 23 Département de l'Instruction publique N° 1709-53.Québec, le 26 mai, 1954.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 19 mai 1954, d'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"La municipalité scolaire de Weedon, dans le comté de Wolfe\" le territoire des municipalités scolaires actuelles de Weedon Canton et Weedon Centre village, même comté.Le territoire de cette future municipalité comprendra les lots suivants, tous inclusivement du Canton Weedon: 1 à 13-B rang I; 1 à 13-11 rang II; 1 à 13-C rang III; 1 à 28 rangs IV et V; 1 à 20 rangs VI, VII, VIII et IX.Cette arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1954.Le Surintendant de l'Instruction publique, 37310-o 0.J.DÉSAULNTERS.N° 613-53.Québec, le 26 mai, 1954.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil par arrêté ministériel en date du 19 mai 1954, d'annexer le territoire actuel de.la municipalité scolaire de la paroisse de St-.Tean, dans le comté de St-Jean, aux municipalités scolaires de la Cité de St-Jean et de Notre-Dame-Auxiliatrice, dans le même comté, de la manière suivante, savoir: 1.a) Que le territoire ci-dessous décrit soit annexé à la municipalité scolaire de la Cité de St-Jean, dans le comté de St-Jean, savoir: partant d'un point situé au centre de la rivière Richelieu, vis à vis le prolongement vers l'est de la ligne sud du lot N° 19 du cadastre de la paroisse de St-Jean, de ce point de départ susdit, en longeant cette ligne fictive du centre «le la rivière jusqu'au coin sud-est de cedit lot N° 19 et en longeant ensuite le côté sud dudit lot N° 19 jusqu'au lot N° 163; de là vers le nord au trait carré des lots 19 à 39 inclusivement et 31 à 40 inclusivement du coin nord-ouest de ce dernier lot en longeant vers l'ouest la ligne sud du lot N° 137 jusqu'au lot N° 186 et de là vers le sud en longeant le trait carré des lots jusqu'au coin sud-est du lot N° 168 et ensuite vers le nord-ouest jusqu'à la ligne ouest du lot N° 183 et de là en longeant le trait carré des lots jusqu'au coin nord-ouest du lot N° 202 et de là vers l'est jusqu'au chemin du Petit Bernier pour longer le côté ouest dudit chemin jusqu'à la ligne sud du lot N° 207; de là vers l'ouest jusqu'au coin sud-ouest de ce dernier lot; de là vers le nord en longeant le trait carré des lots jusqu'au coin nord-ouest du lot X° 211 ; de là vers l'est jusqu'au chemin du Petit Bernier; de là en longeant le côté ouest de cedit chemin jusqu'au lot N° 220; de là vers l'ouest jusqu'au coin sud-ouest de ce dernier lot et de là vers le nord et nord-est en suivant le trait carré des lots jusqu'au coin nord-ouest du lot N° 91 ; de là en suivant la ligne nord du lot 91 jusqu'à son extrémité est; la ligne nord-est des lots 91 et 92; le ligne est des lots 92 et 93 jusqu'au côté nord de la voie d'évite-ment des chemins de fer Natiouaux du Canada; Department of Education No.1709-53 Quebec, May 26, 1954.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated May 19, 1954, has been pleased to erect into a separate school municipality, under the name of \"The School Municipality of Weedon, in the County of Wolfe\", the territory of the existing school municipalities of thé Township of Weedon and Weedon Centre village, same county.The territory of the proposed municipality will include the following lots, all inclusively of Weedon township; 1 to 13, B Range I, 1 to 13 II, range II; 1 to 13 C, range III; 1 to 28, ranges IV and V; 1 to 20, ranges VI, VII, VIII and IX.This order in Council will take effect on July 1st, 1954.O.J.DÉSAULNIERS, 37310 Superintendent of Education.No.613-53 Quebec, May 26, 1954.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated May 19, 1954, has been pleased to annex the territory of the existing school municipality of the Parish of St.John, in the County of St.Jean, to the school municipalities of the City of St.John and Notre-Dame-Auxiliatrice, in the same county, in the following manner, to wit: 1.a), That the territory hercinunder described be annexed to the school municipality of the city of St-John, in the county of St-John, to wit: starting from a point situate in the center of the Richelieu River, facing the prolongation on the east of the south line of lot No.19, of the cadastre of the parish of St-John, from the above mentioned starting point, following this fictitious center line of the river to the southeast corner of the said lot No.19 and afterwards following the south side of the said lot No.19, as far as lot No.163; thence, on the north to the \"trait-carré\" of lots 19 to 39 inclusively and 31 to 40 inclusively, from the northwest corner of this latter lot, by following on the west the south line of lot No.137 as far as lot No.186 and thence on the south by following the \"trait varré\" of the lots as far as the southeast corner of lot No.168 and afterwards on the northwest to the line west of lot No.183, and thence, by following the \"trait-carré\" of lots as far as the northwest corner of lot No.202 and thence on the east as far as the Petit Bernier Road to follow the west side of the said road as far as the south line of lot No.207; thence, on the west, as far as the south-west corner of this latter lot, thence on the north, following the \"trait-carré\" of lots as far as the northwest corner of lot No.211; thence, on the east, as far as the Pctit-Bcrnier Road; thence following, the west side of the said road as far as lot No.220; thence, on the west, as far as the southwest corner of this latter lot and thence on the north and northeast by following the \"trait-carré\" of lots as far as the northwest corner of lot No.91; thence, by following the north line of lot 91 2° La présente ordonnance entrera en vigueur 2.The present order shall come into force on le 1er juin 1954.June 1st, 1954.Signé: Omer-E.Mi lot, président, Signed: Omer E.Mi lot, Président, J.-A.Onartraxd, commissaire, J.-A.ChabtranD, Commissioner, Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.37315-0 37315-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, 1954, Vol.86, No.23 1801 de là vers l'ouest en longeant le côté nord de cette voie d'évitement jusqu'à y compris le droit de passage des voies principales des chemins de fer Nationaux du Canada; de là vers le sud-est en longeant le côté sud-ouest du droit de passage des voies principales des chemins de fer Nationaux dû*-1 Canada jusqu'à la ligne est du lot N° 97; de là vers le sud en longeant la ligne est des lots 97, 98, 100, 102, 108 et 109; la ligne sud de ce dernier lot jusqu'au côté est du chemin du Grand Bcrnier; de là vers le sud jusqu'à la ligne nord du lot 118; de là vers l'est en suivant la ligne nord de celui-ci jusqu'à la ligne ouest du lot 60; de là vers le nord jusqu'à la ligne sud du lot 61 et vers l'est en suivant cette dernière ligne jusqu'aux chemins de fer Nationaux du Canada; de là vers le nord en longeant le côté ouest desdits chemins de fer jusqu'à la ligne nord du lot 62 et ensuite vers l'est en longeant la ligne nord de ce lot 62 jusqu'au centre de la rivière Richelieu et de là vers le sud en suivant une ligne fictive au centre de ladite rivière jusqu'au point de départ.b) Que le territoire ci-dessous décrit soit annexé à la municipalité scolaire de Notre-Damc-Auxiliatricc, dans le même comté, savoir: tous les lots 78 à 89 inclusivement de la première concession de la rivière Richelieu du cadastre officiel de la paroisse de St-Jean.2.Que soit détaché de la municipalité scolaire de St-Luc, comté de St-Jean, le lot 90 dudit cadastre officiel de la paroisse de St-Jean, pour être annexé à la municipalité scolaire de la Cité de St-Jean, dans le même comté.Cette arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1954.Le Surintendant de l'Instruction publique, 3731G-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 418-45.Québec, le 25 mai, 1954.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 19 mai, 1954, d'ériger en municipalité scolaire distincte, poulies contribuables catholiques seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire catholique de St-Mathias-de-Bonnetcrre, dans le comté de Compton\", le territoire ci-dessous décrit qui est détaché des municipalités scolaires de Newport.St-Isidore-d'Auckland et St-Jean-Baptiste-d'Em-berton, dans le même comté.Le territoire de cette future municipalité est compris dans les limites ci-dessous décrites, savoir: Partant du csin nord-ouest du lot 17-A du rang VIII du canton Newport, en allant vers l'est en suivant les lignes et démarcations suivantes en continuité les unes des autres, savoir: La ligne de division entre les rangs VII et VIII du canton de Newport jusqu'à la limite est du canton de Newport.De là vers le sud, la ligne de division entre les cantons de Newport et de Ditton jusqu'au coin nord-ouest du lot I du rang IX du canton Ditton; De là vers l'est, la limite nord des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dudit rang dudit canton jusqu'au coin nord-est de ce dernier lot; $ De là vers le sud, la ligne de division entre les lots 7 et 8 des rangs IX, X et XI du canton Ditton as far as its eastern extremity; the northeast line of lots 91 and 92; the east line of lots 92 and 93 as far as the north side of the siding of the Canadian National Railways; thence, on the west, following the north side of this siding up to and including the right of way of the main lines of the Canadian National Railways, thence on the southeast, following the southwest side of the right-of-way of the main lines of the Canadian National Railways as far as the east lines of lot No.97; thence, on the south, following the east line of lots 97, 98, 100, 102, 108 and 109, the southern line of this last lot as far as the eastern side of the Grand Bernier Road; thence, on the south, as far as the northern line of lot 118, thence on the east, following the northern line of the latter as far as the western line of lot CO; thence, on the north, as far as the southern line of lot 61 and on the east by following this last line to the Canadian National Railway lines of Canada; thence on the north, by following the western side of the said railroad as far as the northern line of lot 62 and then on the est by following the northern line of this lot 62 to the center of the Richelieu River and thence on the south by following a fictitious line through the center of the said river to the starting point.b) that the territory hercinunder described be annexed to the school municipality of Notre-Dame-Auxiliatrice, in the same county, to wit: all the lots 78 to 89 inclusively from the first concession of the Richelieu River in the official cadastre of the parish of St-John.2.That lot 90 of the said official cadastre of the parish of St-John be detached from the school municipality of St-Luc, county of St-John, and annexed to the school municipality of the city of St-John, in the same county.This order in Council will take effect on July 1st, 1954.O.J.DÉSAULNIERS, 37316 Superintendant of Education.No.418-45.Quebec, May 25, 1954.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated May 19, 1954, has been pleased to erect into a separate school municipality, for Catholic ratepayers only, under the name of \"The Catholic School Municipality of St.Mathias-de-Bonneterre, in the County of Compton\", the territory hereinunder described which has been detached from the school municipalities of Newport, St.Isidore-d'Auckland and St.Jean-Baptiste-d'Emberton, in the same county.The territory of this future municipality is included within the limits hereinunder described: Starting from the Northwest corner of lot 17-A of Range VIII of the Township of Newport, going towards the East by following the following lines and demarcations successively, to wit: The dividing line between ranges VII and VIII (7 and 8) of the township of Newport as far as the Eastern limit of the township of Newport; Thence, towards the South, the dividing line between the townships of Newport and of Ditton as far as the Northwest corner of lot I of range IX (9) of the Ditton township; Thence, towards the East, the Northern limit of lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said range of the said township as far as the Northeast corner of this latter lot: Thence, towards the South, the dividing line between lots 7 and 8 of ranges IX, X and XI 1802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 195A, Tome 86, N° S3 et cette môme ligne entre les lots 46 et 47 du rang I du canton Emberton jusqu'aux limites sud dudit canton soit la limite entre la Province de Québec et l'État du New-Hampshire; De là en suivant cette ligne entre la Province de Québec et les États Unis dans une direction générale sud-ouest jusqu'à sa rencontre avec le coin sud-ouest du lot N° 19 du rang VII du canton Auckland; * De là vers le nord, la ligne ouest dudit lot jusqu'à la ligne entre les rangs Vn et Vin dudit canton ; De là vers l'ouest, cette dernière ligne jusqu'à la ligne entre les lots 17 et 18 du rang Vin de ce même canton; De là vers le nord la ligne separative des lots 17 et 18 des rangs VIII et IX jusqu'à la ligne separative des rangs IX et X; De là vers l'ouest, cette ligne jusqu'à la ligne de division entre les lots 13 et 14 du rang X; De là dans une direction nord en suivant cette dernière ligne jusqu'à la ligne entre les rangs X et XI; De là vers l'ouest en suivant cette ligne jusqu'à la ligne entre les lots 6 et 7 du rang XI; De là vers le nord en suivant la ligne entre les lots 6 et 7 du rang XI du canton d'Auckland et 8 et 9 des rangs XI et X du canton Newport jusqu'au coin nord-ouest du lot 9-C du rang X du canton Newport; De là vers l'est, la limite des lots 9-C, 10-C et 11-C dudit rang; De là vers le nord, la ligne entre les lots 11 et 12 des rangs X et IX dudit canton jusqu'au coin nord-ouest du lot 12-B du rang IX; De là vers l'est, la limite nord des lots 12-1$, 12-C.13-B, 13-C, 14-B, 14-C, 15-15, 16-B et 16-C jusqu'au coin nord-est de ce dernier lot.De là vers le nord, la ligne separative des lots 16 et 17 des rangs IX et VIII jusqu'au point de départ, soit le coin nord-ouest du lot 17-A rang VIII, canton Newport.Cet arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1954.Le Surintendant de l'Instruction publique, 37316-0 0.J.DÉSAULNLERS.N° 986-53.Québec, le 1er juin, 1954.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 25 mars 1954, de former en municipalité scolaire distincte, pour les contribuables protestants seulement, sous le nom de \"The Protestant School Municipality of Ile Perrot in the county of Vaudreuil Soulanges\" tout le territoire actuel de l'Ile Perrot.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1954.Le Surintendant de l'Instruction publique, 37316-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 404-54.Québec, le 1er juin 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Georges-Ouest, paroisse, dans le comté de Beauce, le lot N° 110 du rang Bord-de-PEau, du cadastre officiel de la paroisse de St-Georges-Oucst, pour l'annexer à la muni- (9, 10 and 11) of the Ditton township and this same line between lots 46 and 47 of ranges I (1) of Emberton township as far as the Southern limits of the said township, albeit the limit between the Province of Quebec and the State of New Hampshire; Thence, by following this line between the Province of Quebec and the United States in a general Southwesterly direction to the point where it meets with the Southwest of corner lot No.19 of Range VII of the township of Auckland; Thence, towards .the North, the Western line of the said lot as far as the line between ranges VII and VIII (7 and 8) of the said township; Thence, on the West, this latter line as far as the line between lots 17 and 18 of Range VIH (8) of this same township; Thence on the North, the dividing line of lots 17 and 18 of ranges VIII and IX as far as the dividing line of ranges IX and X (9 and 10); Thence, on the West, this line as far as the dividing line between lots 13 and 14 of range X; Thence, in a Northerly direction by following this latter line as far as the line between ranges X and XI (10 and 11); Thence, on the West by following this line as far as the line between lots 6 and 7 of range XI (11); Thence, on the North by following the line between lots 6 and 7 of Range XI (11) of the township of Auckland and 8 and 9 of ranges XI and X (11 and 10) of the Newport Township; as far as the Northwest corner of lot 9-C ranges X of the townships of Newport; Thence, on the East, the Northern limit of lots 9-C, 10-C, and 11-C of the said range; Thence, on the North, the line between lots 11 and 12 of ranges X and IX of the said township as far as the Northwestern corner of lot 12-B of range IX (9); Thence, on the East, the Northern limit of lots 12-B, 12-C, 13-B, 13-C, 14-B, 14-C, 15-B, 16-B and 16-C as far as the Northeastern corner of this latter lot.Thence, on the North, the dividing line of lots 16 and 17 of ranges IX and VIII (9 and 8) as far as the starting point, albeit the Northwestern corner of lot 17-A range VIII Newport Township.This order in Council will take effect July first 1954.0.J.DÉSAULNIERS, 37316 Superintendant of Education.No.986-53.Quebec.June 1st.1954.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated March 25, 1954, has been pleased to erect into a separate school municipality for protestant rate-payers only, under the name of \"The Protestant School Municipality of He Perrot, in the County of Vaudrcuil-Soulanges\", all the present territory of He Perrot.This Order in Council will come into effect on July first 1954.O.J.DÉSAULNIERS, 37316 Superintendent of Education.No.404-54.Quebec, June first, 1954.Application is made to detach from the school municipality of St.Georges-West, parish, in the County of Beauce, lot No.110 of Range Bord-de-l'Eau, of the official cadastre of the Parish of St.Georges-West, in order that it be annexed QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 5th, 1054, Vol.86, No.23 1803 cipalité scolaire de St-Georges-de-Beauce, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 37302-23-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 524-54.Québec, le 2 juin, 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Stanbridge-Est, dans le comté de Missisquoi, la partie des lots 2386, 2387 et 2390 contenant 25 acres de terrain, du cadastre officiel de Stanbridge-Est, pour l'annexer à la municipalité scolaire protestante de Bedford, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 37375-23-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg (cité de Québec) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 717-37 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 26 mai 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 37364-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Grantham (Municipalité de la paroisse de St-Germain-de-Gran-tham) Division - d'enregistrement de Drummond.Avis est par la présente donné (pie les lots 713-1 à 713-15, 714-1 à 714-5 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 26 mai 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 37364-0 AVILA BÉDARD.Département du Travail Avis d'approbation* de règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité conjoint de l'industrie de la peinture, établi en exécution du décret numéro 193 du 11 mars 1954 et dont le siège social est situé dans la cité de Montréal, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 547 du 28 mai 1954 (section \"A\").Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 5 juin 1954.37352-0 to the school municipality of St.Georges-de-Beauce, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 37362-23-2 Superintendent of Education.No.524-54.Quebec, June 2, 1954.Application is made to detach from the school municipality of Stanbridgc-East, in the County of Missisquoi, that part of lots 2386, 2387 and 2390 containing 25 acres of land, of the official cadastre of Stanbridge-East, in order to annex it to the Protestant school municipality of Bedford, same County.O.J.DÉSAULNIERS, 37375-23-2 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of Charlesbourg (city of Quebec) registration division of Québec.Notice is hereby given that lot 717-37 is cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May the 26th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, Deputy Minister.37304-o NOTICE Official cadastre of the township of Grantham (Municipality of the parish of St.Germain de Grantham) registration division of Drummond.Notice is hereby given that lots 713-1 to 713-15, 714-1 to 714-5 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May the 26th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 37364-0 Deputy Minister.Department of Labour Notice of approval of By-law The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the constitution and general by-laws of the Joint Committee of the Paint Industry, formed under decree No.193 of March 11, 1954, with head office in the city of Montreal, have been approved by Order in Council No.547 of May 28, 1954 (part \"A\").GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 5, 1954.37352-o M \u2022 M 5 .\\-T.V//7/ K DE QUEBEC, Québec, 5 juin 1964, Tome SG, N° 23 V» ;> *-rv.\\v.OU>\\ »M lu\\:i.KMK\\TS NOTICE OK APPROVAL OF BY-LAWS \u2022)¦.;¦¦.'.¦ AGRICOLE du Québec, (requérant vs J.ALFRED O'CONNOR, de St.Anicet, dit district, intimé.Saisi comme appartenant audit intimé: \"Ce lot de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Saint-Anicet et de Sainte-Barbe, sous le numéro 857 contenant environ 200 acres en superficie, plus ou moins, avec toutes les bâtisses dessus construites.Servitude: Servitude établie en faveur de The Shawinigan Water and Power lui donnant le droit d'ériger des poteaux et des ancres, laquelle dite servitude a été passée par devant le notaire L.Baillargeon, le premier jour du mois d'août 1947, et enregistrée au bureau d'enregistrement du comté de Huntingdon sous le N° 51830.Réserve: Par acte de vente par devant le notaire Baillargeon, le 26 novembre 1945 et enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Huntingdon, sous le N° 50119 lequel a été consenti par Aldoma Caza en faveur de Lucien Loiselle et J.-P.Besner, ledit Aldoma Caza s'est réservé pour une période de trois années la coupe du bois sur le côté ouest dudit lot N° 857.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de Saint-Anicet, comté de Huntingdon, district de Beauharnois, mercredi, le 16 JUIN 1954, à DIX heures de l'avant-midi, heure avancée.Le Shérif, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER, Valleyfield.10 mai 1954.37200-20-2-o SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Superior Court, l TJTOWARD SMITH PA- No.V-1854 -J -tl PER MILLS LTD, a (corporation legally constituted with head office at 407 McGill Street, Montreal, district of Montreal, garnishor, vs JOSEPH PLANTE, lumber contractor, of Lake Blouin, district of Abitibi, garnishee.NOTICE OF SALE Rights acquired on lot 22, Range I of the Township of Senneville, district of Abitibi, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies; To be sold at the parochial church door of Val Senneville, THURSDAY, JULY FIFTEENTH 1954, at TWO o'clock in the faternoon, Daylight Saving Time.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, May 31, 1954.37349-23-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Beauharnois Superior Court, ( /QUEBEC FARM CREDIT No.1305.< VC BUREAU, plaintiff, vs (j.ALFRED O'CONNOR, of Saint-Anicet, said district, defendant.Seized as belonging to said defendant: \"That lot of land known and designated on the plan and book of reference of the official cadastre of the parish of St.Anicet and St.Barbe, undr number 837 containing about 200 acres in area, more or less, with all buildings erected thereon.Servitude: A servitude established in favour of The Shawinigan Water and Power, with the right to erect poles and anchors, which servitude was passed before notary L.Baillargeon, the first day of the month of August, 1947, and registered at the Registry Office of the County of Huntingdon under No.51830.Reservation: Per deed of sale passed before Notary Baillargeon, November 26, 1945 and registered at the Registry Office of the County of Huntingdon, under No.50119, consented thereto by Aldoma Caza in favour of Lucien Loiselle and J.-P.Besner, the said Aldoma Caza reserving the right, for a period of three years, of cutting wood on the west side of said lot No.857.\" To be sold at the parochial church door of the Parish of St.Anicet, County of Huntingdon, district of Beauharnois, WEDNESDAY, JUNE 16, 1954, at TEN o'clock in the forenoon, Daylight Saving Time.ERNEST POIRIER, Sheriff's Office, Sheriff.Valleyfield May 10th, 1954.37200-20-2-e 1826 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 juin 1964, Tome 86, N° 23 HULL District de Hull Cour Supérieure./ JEAN BAPTISTE NOR-N° 277Ô.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.