Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 décembre 1954, samedi 18 (no 51)
[" Tome 86, N° 51 3765 Vol.86, No.51 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Ceo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 18 décembre 1954 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est* publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, December 18th, 1954 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same js transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1964, Tom* 86, N° 61 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi A condition que l'un des trois derniers jours de In semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.* 8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans ¦ line première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 1 5 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 260 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec.27 juin 1940.31753 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case,'the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received ou time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 206 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: S7.per year.\u2022 N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.31753 \u20141-52 Lettres patentes Letters Patent -V;- - (P.G.12910-54) (A.G.12910-54) Allied Cartage & Warehouses Inc.Allied Cartage & Warehouses Inc.' Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, des lettres patentes en'date du Province of Quebec, bearing date the twenty - vingt-cinq novembre 1954, constituant en corpo- fifth day of November, 1954, incorporating: ration: Guy Bernard Baillargeon, industriel, Guy Bernard Baillargeon, industrialist, Clement Clément Beauregard, comptable, et Jacques Beauregard, accountant, and Jacques Raymond, Raymond, comptable agréé, tous des cité et chartered accountant, all of the city and judicial district judiciaire de Montréal, pour les objets' district of Montreal, for the following purposes: suivants: Exercer le commerce d'entreposeurs et proprié- To carry on the business of warehousemen and taircs de quais, sous le nom de \"Allied Cartage wharfingers, under the name of \"Allied Cartage & Warehouses Inc.'', avec un capital de $10,000, & Warehouses Inc.\", with a total capital stock divisé en 1,000 actions de $10 chacune.of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.Le siege social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General, cinq novembre 1954.this twenty-fifth day of November, 1954.L'Assistant-procureur général, C.E.CANTIN, 38817 C.E.CANTIN.38817-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 3767 (P.G.12879-54) Ant.I.abbe Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1954, constituant en corporation: Antonio Labbé, garagiste, Clément Labbé, vendeur, et Valérien Cliche, comptable, tous de Vallée-Jonction, district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Ant.Labbé Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Vallée-Jonction, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12690-54) Barry Explorations Limited Avis est donné qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize novembre 1954, constituant en corporation: Agnès Barry, secrétaire, épouse de John F.Barry et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Leona Green, tencuse de livres, célibataire, et Michael Ettinger, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines, minerais et gisements d'huile, sous le nom de \"Barry Explorations Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 200 actions catégorie \"A\" d'une valeur au pair de $100 chacune, 500 actions catégorie \"B\" d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,500 actions catégorie \"C\" d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 C.E.CANTIN.(P.G.12672-54) Beau-Mount Furs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1954, constituant en corporation: Emile Elias, marchand, Alice Khazoom Elias, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Emile Elias, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Sherbrooke, et Elie Elias, marchand, de Richmond,, tous du district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fourrures, sous le nom de \"Beau-Mount Furs Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(A.G.12879-54) Ant.Labbé Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1954, incorporating: Antonio Labbé, garage-keeper, Clément Labbé, salesman, and Valérien Cliche, accountant, all of Vallée-Jonction, judicial district of Beauce, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, under the name of \"Ant.Labbé Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Vallée-Jonction, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12690-54) Barry Explorations Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Agnès Barry, secretary, wife of John F.Barry, and duly authorized by him for the purposes of these presents, Leona Green, bookkeeper, spinster, and Michael Ettinger, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines, minerals and oil wells, under the name of \"Barry Explorations Limited\", with a total capital stock of $50,000.divided into 200 class \"A\" shares of a par value of 8100 each, 500 class \"B\" shares of a par value of $10 each and into 2,500 class \"C\" shares of a par value of 810 each.The head office of the company will-be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-0 Deputy Attorney General.(A.G.12072-54) Beau-Mount Furs Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1954, incorporating: Emile Elias, merchant, Alice Khazoom Elias, housekeeper, wife, separate as to property by marriage contract of the said Emile Elias, and duly authorized by the latter for these present purposes, both of Sherbrooke, and Élie Elias, merchant, of Richmond, all of the judicial district of St.Francis, for the following purposes: To deal in furs under the name of \"Beau-Mount Furs Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General. 3768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1054, Tome 86, A'° 51 (P.G.125S9-54) Blouin & Boutin Construction Ltée Blouin & Boutin Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1904.constituant en corporation: Guy-E.Boivert, avocat, Jean Marien et Pierre Marien, comptables, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Blouin & Boulin Construction Ltée \u2014 Blouin & Boutin Construction Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4.000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 CE.CANTIN.(P.G.12608-54) Dufrcsne, Frank & Delislc Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de.la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Marcel La jeunesse, Jean-Paul Cardinal, Jacques P.Dansereau.avocats, de Montréal, I.ovcll C.Carroll.Conseil en Loi de la Reine, de Ville Mont-Royal et Denise Jalbert, secrétaire, fille majeure, de Verdun, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de matériaux de construction et aussi agir comme fournisseurs; négocier des propriétés immobilières et exercer tous et aucun des commerces d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Dufrcsne.Frank & Delislc Inc.\".avec un capital total de §15,000, divisé en 15,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 C.E.CANTIN.(P.G.12808-54) - Garage St-Léon, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-Huit novembre 1954, constituant en corporation: Henri Beaupré, Pierre Choquette, avocats, et Béatrice Plante, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires connue garagistes, et exercer le commerce de véhicules automobiles et d'appareils électriques, sous le nom de \"Garage St-Léon, Limitée\", avec un capital total de §15,000, divisé en 150 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Léon-le-Grand, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-o \u2022 C.E.CANTIN.(A.G.125S9-54) Blouin & Boutin Construction Ltée Blouin & Boutin Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1954, incorporating: Guy-E.Boisvert, advocate, Jean Marien and Pierre Marien, accountants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on operations as general contractors and builders, under the name of \"Blouin & Boutin Construction Ltée \u2014 Blouin & Boutin Construction Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at.Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12608-54) Dufrcsne, Frank & Dclisle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Marcel Lajeuncsse, Jean-Paul Cardinal, Jacques P.Dansereau, advocates, of Montreal, Lovell C.Carroll, Queen's Counsellor, of the town of Mount Royal, and Denise Jalbert, secretary, spinster of the full age of majority, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in building and construction materials and suppliers; to deal in immoveable property and to carry on all or any of the businesses of general contractors and builders, under the name of \"Dufresne, Frank & Dclisle Inc.\", with a total capital stock of 815,000, divided into 15,000 common shares of a par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-o Deputy Attorney General.(A.G.12808-54) Garage St-Léon, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1954, incorporating: Henri Beaupré, Pierre Choquette, advocates, and Béatrice Plante, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to deal in motor vehicles and electrical appliances under the name of \"Garage St-Léon, Limitée\", with a total capital stock of 815,000, divided into 150 shares of 8100 each.The head office of*\"the company will be at St-Léon-le-Grand, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 195A, Vol.86, No.01 3709 (P.G.10086-54) Georges Gaudette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf novembre 1954, constituant en corporation: Georges Gaudette, commerçant.René Rivet, comptable, et Jean-Maurice Charbonneau, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de \"Georges Gaudette Inc.\", avec un capital total de 8200,000, divisé en 12,000 actions communes d'une valeur au pair de S10 chacune et en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12827-54) J.Chas Martel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1954, constituant en corporation: Jean-H.Deslauriers, avocat, d'Outre-mont, Roma Cousineau, avocat, de Verdun, et Denyse Lachance, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du bois, de ses produits et sous-produits et de toutes choses dans la fabrication desquelles entre le vois, sous le nom de \"J.Chas Martel Inc.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 10,-000 actions communes de 81 chacune et en 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre, 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12821-54) La Chaussure de Sécurité Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1954, constituant en corporation: Arthur-J.Gagnon, marchand, Patricia Bouchard, dactylographe, tous deux de ville d'Alma, et Joseph Brassard, industriel, de Hébertville-Station, tous du district de Ro-berval, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de chaussures, sous le nom de \"La Chaussure de Sécurité Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hébertville-Station, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, ic vingt-deux novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-o C.E.CANTIN.(A.G.10086-54) Georges Gaudette Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of November, 1954, incorporating: Georges Gaudette, dealer.René Rivet, accountant, and Jean-Maurice Charbonneau, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in electrical appliances and accessories, under the name of \"Georges Gaudette Inc.\", with a total capital stock of S200.000, divided into 12,000 common shares of a par value of $10 each, and into 800 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12827-54) J.Chas Martel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1954, incorporating: Jean-H.Deslauriers, advocate, of Outremont, Roma Cousineau, advocate, of Verdun, and Denyse Lachance, secretary, spinster in use of her rights, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and deal in wood, products and by-products thereof and in all things into which the manufacture thereof requires wood, under the name of \"J.Chas Martel Inc.\", with a total capital stock of $100,000.divided into 10,000 common shares of $1 each and into 900 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12821-54) La Chaussure de Sécurité Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November.1954, incorporating: Arthur-J.Ganon, merchant, Patricia Bouchard, typist, both of the town of Alma, and Joseph Brassard, industrialist, of Hébertville-Station, all of the judicial district of Rqberval, for the following purposes: To manufacture and operate a business dealing in shoes, under the name of \"La Chaussure de Sécurité Inc.\", with' a total capital stock of S10.000, divided into 100 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Hébertville-Station, judicial district of Robervaf.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General. 3770 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1951, Tome 86, N° 61 (P.G.12522-54) Les Immeubles Maisonneuve Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre, 1954, constituant en corporation: Gilles Le Blanc, avocat, d'Outremont, Robert-E.Fuscy, avocat, et Madeleine Crépeau, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, de Montréal, tous du district.judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Maisonneuve Limitée\", avec un capital total de 850,000, divisé en 10,000 actions communes de SI chacune et en 400 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-o C.E.CANTIN.(P.G.12590-54) Louis M.Morin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf novembre 1954.constituant en corporation: Louis-Marie Morin, agent, Graziella Beau-lieu Morin, ménagère, épouse contractuellemcnt séparée de biens dudit Louis-Marie Morin, et Fernand Pothicr, comptable, tous des cité et district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Acheter, vendre et faire le commerce en gros comme distributeur de bière, sous le nom de \"Louis M.Morin Ltée\", avec un capital total tie §100,000, divisé en 400 actions communes de §100 chacune et en 0,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(G.P.12761-54) Major Provisioners Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize novembre 1954, constituant en corporation: Jacques Blain, Harry Gerson, marchands, David Slopack, Ben Slopack, bouchers, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'aliments, dispositifs, accessoires et articles domestiques, accessoires et matériaux de construction, articles de sport et vêtements, sous le nom de \"Major Provisioners Ltd.\", avec un capital total de §20,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 C.E.CANTIN.(A.G.12522-54) Les Immeubles Maisonneuve Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1954, incorporating: Gilles Le Blanc, advocate, of Outremont, Robert-E.Fusey, advocate, and Madeleine Crépeau, secretary, spinster in use of her rights, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate under the name of \"Les Immeubles Maisonneuve Limitée\", with a total capital stock of S50,000, divided into 10,000 common shares of $1 each, and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of thr Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12590-54) g Louis M.Morin Ltée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of November, 1954, incorporating: Louis-Marie Morin, agent, Graziella Beaulieu Morin, housewife, wife separate by marriage contract as to property of the said Louis-Marie Morin, and Fernand Pothier, accountant, all of the city and judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To buy, sell and carry on a wholesale business as beer distributors, under the name of \"Louis M.Morin Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 400 common shares of $100 each and into 6,000 preferred shares of §10 each.The head office of the company will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12761-54) Major Provisioners Ltd.Notice, is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Jacques Blain, Harry Gerson, merchants, David Slopack, Ben Slopack, butchers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in foods, household, appliances, accessories and articles, building accessories and materials, sporting goods, clothing, under the name of \"Major Provisioners Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 100 preferred snares of a par value of $100 each.» The hea'd office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tins sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 3771 (P.G.12806-54) Metropolitan Building Renovators Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1954, constituant en corporation: Roger St-Amour, Jean St-Amour, courtiers d'immeubles, et Gérard M.McKenny, agent d'immeubles, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'entrepreneur général, sous le nom de \"Metropolitan Building Renovators Incorporated\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3607, rue St-Deuis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12804-54) Montebcllo Woodwork Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1954, constituant en corporation: Ecrnand Lcgault, C.R., avocat, Jean-Guy Joannette, avocat, et Aline Dcsjardins, secrétaire, célibataire, tous de Lachute, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bois sous toutes ses formes et tous autres commerces qui s'y rattachent, sous le nom de \"Montebello Woodwork Limited\", avec un capital total de $75,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera dans le village de Montebello, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P\\G.12835-54) Newton Lumber Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1954, constituant en corporation: Maurice Arsenault, menuisier, Jean-Paul Arsenault, contremaître, tous deux de Sainte-Justine-de-Newton, et René Berge vin, marchand, de Saint-Bruno, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois, quincaillerie et matériaux de construction et exploiter un moulin à farine, sous le nom de \"Newton Lumber Ltd\", avec un capital total de $100,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 850 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(A.G.12806-54) Metropolitan Building Renovators Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1954, incorporating: Roger St-Amour, Jean St-Amour, real estate brokers, and Gérard M.McKenny real estate agent, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a general contractor under the name of \"Metropolitan Building Renovators Incorporated\", with a total capital stock of S20.000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 3607 St-Louis Street, Montreal, judicial district of Montreal.- Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12804-54) Montebello Woodwork Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1954, incorporating: Fernand Legault, Q.C., advocate, Jean-Guy Joannette, advocate, and Aline Desjardins, secretary, spinster, all of Lachute, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To deal in wood in all its forms and in all other businesses pertaining thereto, under the name of \"Montebello Woodwork Limited\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 shares of 8100 each.The head office of the company will be in the billage of Montebello, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General,* this eighteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12835-54) Newton Lumber Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1954, incorporating: Maurice Arsenault, joiner, Jean-Paul Arsenault, foreman,' both of Sainte-Justinerde-Newton, and René Bergevin, merchant, of Saint-Bruno, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in wood, hardware and building materials and to operate a flour mill, under the name of \"Newton Lumber Ltd\", with a total capital stock of $100,000, divided into 150 common shares of a par value of $100 each and into 850 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General. 3772 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1964, Tome 86, N° 51 (P.G.12906-54) Real Phonograph Amusement Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1954, constituant en corporation: Louis Collard, secrétaire, Joseph Yallières, avocat, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, et Real Pinsonnault, commerçant, de Marievillc, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Exercer le commerce de toutes marchandises pouvant faire l'objet d'un commerce de restaurant, sous le nom de \"Real Phonograph Amusement Inc.\", avec un capital total de 840,000 divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à-Marie-ville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12795,54) Salon Ccndrillon Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la proyince de Québec des lettres patentes, en date dix-sept novembre 1954, constituant en corporation: Normand Grimard, Gérald Ryan, avocats, tous deux de Noranda, et Denise Cor-riveau, secrétaire, fille majeure, de Rouyn, tous du district judiciaire de Rouyn-Noranda, poulies objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de chaussures, marchandises sèches, vêtements et accessoires, sous le nom de \"Salon Cendrillon Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn.district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12658-54) Snowdon Realty Holding Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de novembre 1954, constituant en corporation : Sol Schnapp, agent, Joseph Leznoff, comptable et Mary Segal, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Snowdon Realty Holding Company Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 C.E.CANTIN.(A.G.12906-54) Real Phonograph Amusement Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1954, incorporating: Louis Collard, secretary, Joseph Vallière, advocate, both of the city and judicial district of Montreal, and Real Pinsonneault, dealer of Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To deal in all merchandise which may enter into restaurant business, under the name of Real Phonograph Amusement Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of a par value of S100 each and into 250 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12795-54) Salon Ccndrillon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of November, 1954, incorporating: Normand Grimard, Gerald Ryan, advocates, both of Noranda, and Denise Corriveau, secretary, spinster, of Rouyn, all of the judicial district of Rouyn-Noranda, for the following purposes : To manufacture and deal in boots, drygoods, clothing and accessories under the name of \"Salon Cendrillon Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12658-54) Snowdon Realty Holding Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by \"the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Sol Schnapp, agent, Joseph Leznoff, accountant, and Mary Segal, secretary, spinster of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveable property, under the name of \"Snowdon Realty Holding Company Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-0- Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 195A, 1 ol.86, No.51 3773 (P.G.12600-54) Trek a Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Claude Hopwood, comptable, Joseph H, Freeman, avocat, et Sydney Feinstcin, gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, exploiter et administrer une certaine partie de terrain en les cité et district judiciaire de Montréal, sous le nom de \"Tecka Realties Ltd.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1435 rue St-AIexandre.chambre 530, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 C.E.CANTIN.(P.G.12730-54) T.Isabelle Ltée.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize novembre 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: v Entreprendre les affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et air climatisé, sous le nom de \"T.Isabelle Ltée\", avec un capital divisé en 1,000 action ordinaires sans valeur au pair et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 C.E.CANTIN.(P.G.12775-54) Valeartier Poultry Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Yves Pratte.avocat, de Sillery, Charles Tremblay, André Miville-Déchêne, avocats, Gérard Renaud, comptable agréé, et Olga Jur-gens, secrétaire, fille majeure, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de produits agricoles, maraîchers et laitiers, sous le nom de \"Valeartier Poultry Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000.divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur nominale ou au pair de $100 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur nominale ou au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3101 Chemin St-Louis, ville de Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817 1 C.E.CANTIN.(A.G.12660-54) Teeka Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Claude Hopwood, accountant, Joseph H.Frcedman.advocate, and Sydney Feinstcin, .manager, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire, operate ami administer a certain parcel of land in the city and district of Montreal, under the name of \"Teeka Realties Ltd.\", with a total capital stock of S60.000, divided into 300 common shares of S100 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 1435 St.Alexander St., room 530, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-o Deputy Attorney General.(A.G.12730-54) ^ T.Isabelle Ltée.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954 incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Shuster, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in the business of plumbing, heating and air conditioning contractors, under the name of \"T.Isabelle Ltée.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares of no par value and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-0 Deputy Attorney General.(A.G.12775-54) Valeartier Poultry Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1954, incorporating: Yves Pratte, advocate, of Sillery, Charles Tremblay.André Miville-Déchêne, advocates, Gérard Renaud, chartered accountant, and Olga Jurgens.secretary, spinster, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in farm,'garden and dairy products, under the name of \"Valeartier Poultry Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of a nominal or par value of $100 each and into 100 preferred shares of a nominal or par value of $100 each.The head office of the company will be at 3101 St-Louis Iload, town of Ste-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817-o Deputy Attorney General. 3774 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 (P.G.12837-54) Veteran Enterprise» Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf novembre 1954, constituant en corporation: John Primeau, garagiste, Madeleine Riel, secrétaire, tous deux de Montréal, et Norman Cecil Denis, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de transport, sous le nom de \"Veteran Enterprises Limited\", avec un capital total de $80,000, divisé en 800 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12868-54) Vic Metal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt novembre 1954, constituant en corporation: Thomas Grégoire, industriel, Robert Caron et Noël Provencher, gérants, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthavaska, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de la tôle et autres produits métalliques; exercer le commerce d'effets, articles outils, équipements, machines et machineries se rapportant à l'industrie et au commerce ci-dessus; faire affaires comme entrepreneur général, sous le nom de \"Vic Metal Inc.\", avec un capital total de $375,000, divisé en 7,500 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 303, rue Notre-Dame, est, Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.Demandes à la Législature (A.G.12837-54) Veteran Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of November, 1954, incorporating: John Primeau, garage-keeper, Madeleine Riel, secretary, both of Montreal, and Norman Cecil Denis, advocate, of the town of Mount-Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a carrying company under the name of \"Veteran Enterprises Limited\", with a total capital stock of $80,000, divided into 800 shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12868-54) Vic Metal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1954, incorporating: Thomas Grégoire, industrialist, Robert Caron and Noël Provencher, managers, all of Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following puiposes: To carry on the industry and business of sheet metal and other metallic products; to deal in the effects, articles, tools, equipment, machine and machineries pertaining to the above industry and business; to carry on business as general contractor, under the name of \"Vic Metal Inc.\", with a total capital stock of $375,000, divided into 7,500 common shares of $10 each and into 3.000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 303 Notre-Dame Street, East, Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.Applications to Legislature AVIS Avis est par les présentes donné, que les \"Commissaires d'École pour la municipalité du Cap de la Madeleine dans le comté de Cham-plain\", s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour faire confirmer et ratifier à toutes fins que de droit les ententes intervenues entre les commissaires d'École pour la municipalité du Cap de la Madeleine dans le comté de Champlain et certaines industries situées dans les limites du territoire sur lequel, ils ont juridiction; Cap de la Madeleine, 17 novembre 1954.Les commissaires d'Écoles pour la municipalité de la cité du Cap de la Madeleine dans le comté de Champlain.Par le procureur, 38652-48-4-0 LÉON MÉTHOT.NOTICE Notice is hereby given that the \"School commissioners for the municipality of Cap de la Madeleine in the county of Champlain\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec during its present session, to have confirmed and ratified for all legal purposes the agreements concluded between the School commissioners for the municipality of Cap de la Madeleine in the county of Champlain and certain industries situate within the limits of the territory upon which they have jurisdiction; Cap de la Madeleine, November 17th, 1954.School commissioners for the municipality of the city of Cap de la Madeleine in the county of Champlain.LÉON MÉTHOT, 38652-48-4 By the attorney. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1964, Vol.8G, No.61 3775 AVIS Avis par la présente donné que la cité de Chi-coutimi, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à la présente Session pour obtenir la passation d'une loi amendant sa charte, fixant à 8500,000.00 l'évaluation des propriétés de Eastern Smelting and Refining Company Limited dans la cité de Chicoutimi, et pour autres fins.Chicoutimi, ce 19 novembre 1954.Le Greffier de la cité de Chicoutimi, 38053-48-4-o GASTON CARRIER.AVIS Avis est par la présente est donné que Le Club Shawinigan s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour obtenir la passation d'une loi amendant sa charte, définissant ses pouvoirs, abolissant son capital actions, le rendant sujet aux dispositions de la Loi des clubs de chasse et pêche de Québec, et pour autres fins.Montréal, ce 20 novembre 1954.Le Club Shawinigan, Le Secrétaire, 38654-48-4-o JULES BOLDUC.AVIS Avis est par les présentes donné que le Révérend Père Paul Gay, de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, supérieur-, domicilié au Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, Lim-bourg via Hull, comté de Gatineau, province de Québec, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session pour demander la modification de la Loi constituant en corporation le Collège Apostolique Saint-Alexandre de la Gatineau, dans le but d'augmenter les pouvoirs de cette corporation, afin de mieux atteindre les fins pour lesquelles cette corporation a été constituée.Hull, le 18 novembre 1954.Le Procureur du pétitionnaire, 38655-48-4-0 Me PHILLIPE MALTAIS.AVIS PUBLIC La cité de Joliette donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera à la Législature provinciale, lors de la présente session, pour amender sa charte aux fins d'exempter l'imposition des machineries.Joliette, ce 19 novembre 1954.Le Procureur de la pétitionnaire, 38656-48-4-0 ARMAND LA VALLÉE, N.P.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Commission Métropolitaine de Montréal demandera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi pour autoriser l'émission, à un taux n'excédant pas 5%, de l'emprunt décrété par sa résolution numéro 25 du 4 décembre 1946, pour amender la charte de la Commission en vue des circonstances présentes, et particulièrement pour augmenter son fonds de roulement, et pour d'autres fins.Montréal, le 22 novembre, 1954.Le Procureur de la Commission Métropolitaine de Montréal, 38660-48-4-o GASTON POULIOT.NOTICE Notice is hereby given that the city of Chicoutimi will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, fixing the sum of 8500,000.00 as the valuation of the properties of Eastern Smelting and Refining Company Limited in the city of Chicoutimi, and for other purposes.Chicoutimi, this November 19th, 1954.GASTON CARRIER, 38053-48-4 Clerk of the city of Chicoutimi.NOTICE Notice is hereby given that \"Le Club Shawinigan\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the \u2022 passing of an Act to amend its charter, define its powers, abolish its share capital, and render it subject to the provisions of the Quebec Fish and Game Clubs Act, and other purposes.Montreal, this November 20th, 1954.Le Club Shawignigan, JULES BOLDUC, 38654-48-4 Secretary.NOTICE Notice is hereby given that Reverend Father Paul Gay, of the Congregation of the Fathers of the Holy Gost, superior, domiciled at Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, Limbourg via Hull, county of Gatineau, Province of Quebec, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for an amendment to the Act incorporating the \"Collège Apostolique Saint-Alexandre de la Gatineau\" with a view in increasing the powers of the said corporation in order to enable the said corporation to reach the objectives for which it was incorporated.Hull, November 18th, 1954.Me PHILIPPE MALTAIS, 38655-48-4-0 Solicitor for the petitioner.PUBLIC NOTICE The city of Joliette does hereby give notice that it will apply at the Provincial Legislature, at its present session, to amend its charter for the purposes of exempting assessment of machinery.Joliette, this 19th, November, 1954.ARMAND LA VALLÉE', N.P., 38656-48-4-0 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that The Montreal Metropolitan Commission will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act to authorize the issue of a loan decreed by its resolution number 25 dated December 4, 1946, at a rate not exceeding 5%, to amend its charter in view of the present circumstances, and in particular to increase its revolving fund, and for other purposes.Montreal November 22nd, 1954.GASTON POULIOT, Attorney for the Montreal 38660-48-4-o Metropolitan Commission. 3776 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville de Sept-Iles s'adressera à la législature à sa présente session, aux fins de demander l'autorisation de diviser la Ville en trois (3) quartiers, \u2014 d'augmenter la taxe personnelle de $2.00 à $5.00,\u2014 d'imposer une taxe de vente de 2% et de déterminer que le lot 10 du rang I du canton Letellicr n'a jamais fait partie du territoire de la Ville.Le Procureur de la pétitionnaire, 38669-48-4-0 (Signé) HONORÉ DIONNE.AVIS PUBLIC Avis est donné de la ville d'Acton Vale et les commissaires d'écoles pour la ville d'Acton Vale feront à la Législature de la province de Québec, à sa présente session une demande conjointe pour avoir la permission d'imposer dans leurs territoires respectifs une taxe de vente de 2% et une taxe d'éducation de 1%.Avis est aussi donné que la ville d'Acton Vale, dans la même demande, priera la Législature de la province de Québec: 1° De lui accorder la permission d'emprunter par règlement une somme n'excédant pas soixante mille dollars pour acquérir ou construire des immeubles devant servir à des fins municipales ou industrielles.2° De lui accorder la permission d'annexer un terrain faisant partie de la municipalité de Saint-André d'Acton, ledit terrain décrit comme suit: les lots N° 363, 364, 368, 369, 370 ainsi que partie des lots 367, 366, 371 et 372 du cadastre officiel de la paroisse de Saint André d'Acton.3° Et pour autres.Acton Vale, le 22 novembre 1954.Le Procureur de la ville d'Acton Vale et de la Commission scolaire de la ville d'Acton Vale, 38671-48-4-0 JACQUES BOUSQUET.AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Dorval, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présent session, pour l'adoption d'une loi, amendant sa charte, la Loi 14 Georges VI, chapitre 120 et amendements, sur les matières suivantes: droit de percevoir une taxe d'affaires sur les commerces imposer une taxe de 2% pour fins municipales; réglementer l'emploi des excédents des différents règlements d'emprunt non utilisés; annexion de la moitié du Chemin des Sources, faisant front au territoire de la ville; et pour autres fins.Montréal, le 22 novembre 1954.Les Procureurs de la ville de Dorval, LACROIX, VIAU & POUPART.38672-48-4-0 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que La Corporation de téléphone de Québec, La Compa-nie de téléphone du golfe St-Laurent Limitée, The Bonaventure & Gaspé Telephone Company Limited, s'adresseront à la Législature tie la Province de Québec à la session 1954-55 pour demander l'adoption d'un Bill aux fins suivantes: PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Town of Sept-Iles will apply to the Legislature at its present session for the purposes of requesting the authorization to divide the Town into three (3) wards,\u2014 to increase the personal tax from $2.00 to $5.00,\u2014to impose a sales tax of 2% and to settle the fact that lot 10 of Range I of Letellier Township has never been a part of the territory of the Town.(Signed) HONORÉ DIONNE, 38669-48-4 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the town of Acton Vale and the School Commissionncrs for the town of Acton Vale will make a joint request to the Quebec Legislature at its present session to obtain permission to impose in their respective territories «à 2% sales tax and a 1% education tax.Notice is also given that in the same request the town of Acton Vale will ask the Quebec Legislature: 1.To be authorized to borrow by by-law an amount not exceeding sixty thousant dollars to acquire or build immoveables which shall serve for municipal or industrial purposes; 2.To permit annexation of a piece of land, being part of the municipality of St.André d'Acton, the said piece of lantl described as follows: lots numbers 363, 361, 368, 369, 370 as well as part of lots 367, 366, 371 and 372 of the official book and cadastre of the parish of St-André d'Acton, 3.And for other purposes.Acton Vale, November 22nd, 1954.JACQUES BOUSQUET, Attorney for the town and the School Connu i- sioners of Acton Vale.38671-48-4-0 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Dorval will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 14 George VI, chapter 120 and amendments, for the following purposes: right to to collect a business tax on the trades; to impose a 2% tax for municipal purposes; to regulate the use of excess of different loan by-laws non employed; annexation of the half of Chemiu ties Sources, in front of territory of the town; antl for other purposes.Montreal, November 22nd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, The Attorneys for the town of Dorval.38672-48-4-0 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that La Corporation de Téléphone de Québec, La Compagnie de Téléphone du Golfe St-Laurent Limitée and The Bonaventure & Gaspé Telephone Company Limited, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its session 1954-55, for the adoption of a Bill for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December I8U1, 1954, V ol.80, No.51 3777 Obtenir les pouvoirs pour acquérir de gré à gré ou par expropriation, les terrains, droits de passage ou servitudes nécessaires à l'extension de leurs services dans la province de Québec.Rimouski, le 22 novembre 1954.Les Procureurs des pétitionnaires, GAGNON & GAGNON.38673-48-4-n AVIS Avis est, par les présentes, donné que la ville de Mistassini, district de Roberval, s'adressera à la Législature, à sa présente session, pour obtenir la passation d'une loi autorisant l'imposition dans le territoire des municipalités de la ville de Dolbeau, de la ville de Mistassini et de la paroisse de Mistassini, d'une taxe de vente de 2%, ana-loque à la Loi de l'impôt de la vente en détail (S.R.Q.1941 \u2014 chapitre 88), qui devra ôtre perçue par le contrôleur du Revenu de la province et distribuée par lui de la façon suivante: a) Entre la ville de Dolbeau, d'une part, et la ville et la paroisse de Mistassini, d'autre part, au prorata de la population; b) Entre la ville de Mistassini et la paroisse de Mistassini, au prorata de l'évaluation foncière; Ou de toute façon que la Législature voudra bien fixer.Québec, le 24 novembre 1954.Les Procureurs de la pétitionnaire, MAURICE MARQUIS, 38689-48-4-0 ARMAND MALTAIS.Avis est par les présentes que la ville de Tracy et la ville de St.Joseph-de-Sorel, s'adresseront à la Législature de Québec demandant l'adoption d'une Loi accordant le pouvoir de construire et opérer une usine de filtration à frais communs dans les limites de la ville de Tracy.Le Maire de Tracy, ELZÉAR COURNOYER.Le Maire de St.Joseph-de-Sorel, T.AUSSANT.Chs, Parent, C.R., Procureur des requérantes.38700-48-4-o AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la corporation du village de Plessisville s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, dans le but d'obtenir l'adoption d'une loi spéciale aux fins suivantes: 1° L'érection en municipalité de ville de son territoire actuel; \" 2° Fixation de la date des prochaines élections; 3° Autorisation à la dite corporation à emprunter une somme n'excédant pas 860,000.00 destinée à favoriser l'expansion industrielle dans les limites de la municipalité; 4° Octrois de pouvoirs spéciaux concernant les infractions aux règlements municipaux relatifs à la circulation et à la sécurité publique; Et pour autres fins administratives.Plessisville, le 22 novembre 1954.Le Procureur de la Corporation.38697-48-4-0 ROBERT MARCHAND.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de la Côte Notre-Dame de Liesse, dans le comté de Jacques-Cartier, s'adressera à la Législature To obtain the power to acquire \"de gré à gré\" or by expropriation the properties, rights of way or servitudes necessary for the extension of their services in the province of Quebec.Rimouski, November 22nd, 1954.GAGNON & GANON, 38673-48-4-0 Attornies for the petitioners.NOTICE Notice is hereby given that the town of Mistassini, district of Roberval will apply to the Legislature, at its present session, for the adoption of an act authorizing the imposition of a 2% sales tax within the territory of the municipalities of the town of Dolbeau, that of Mistassini and the parish of Mistassini, similar to the Retail Sales Act (R.S.Q.1941\u2014chapter 88), which tax to be collected by the Comptroller of Provincial Revenue and distributed by him in the following manner: a) Between the town of Dolbeau, on one part, and the town and parish of Mistassini, on the other part, proportionately to the population; b) Between the town of Mistassini and the parish of Mistassini, proportionately to land valuation.Or in any other manner which the Legislature would be willing to determine.Quebec, November 24th, 1954.MAURICE MARQUIS, ARMAND MALTAIS, 3S689-4S-4 Attorneys for the petitioner.Notice is hereby given that the town of Tracy and the town of St.Joseph-de-Sorel will apply to the Legislature of Quebec for the adoption of an Act granting them the power to erect and operate a filtration plant, with costs in common, within the limits of the town of Tracy.ELZÉAR COURNOYER, Mayor of Tracy.T.AUSSANT, Mayor of St.Joseph-de-Sorel.Chs.Parent, Q.C., Attorney for the petitioners.38700-48-4 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the corporation of the village of Plessisville will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, with the, object of obtaining the adoption of a special Act, for the following purposes: 1.The rcction of its present territory into a town municipality; 2.To fix the date of the next elections; 3.To give to the said Corporation the authorization to borrow an amount not exceeding 860,000.00 destined to favor the industrial expansion within the limits of the municipality; 4.Grants for special powers concerning infringements against municipal by-laws relative to traffic and public security; And for other administrative purposes.Plessisville, November 22nd, 1954.ROBERT MARCHAND, 38697-48-4 Attorney for the Corporation.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the school commissioners for the parish of Côte Notre-Dame de Liesse, in the county of Jacques-Cartier, shall apply to the Legislature, at its present 3778 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N* 51 à sa présente session, lui demandant l'adoption d'une loi pour décréter que les lots nos.505, 507 et 509 à 515 inclusivement de la paroisse St-Laurent, dans le comté de Jacques-Cartier, font et ont toujours fait partie de la municipalité scolaire de la Côte de Notre-Dame de Liesse et que les redevances scolaires perçues par ladite corporation scolaire, des propriétaires des dits lots ont été légalement perçues et ladite corporation scolaire est autorisée à les retenir.Montréal, le 18 novembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, 38701-48-4-o HENRI COURTEMANCHE.AVIS DE BILL PRIVÉ Avis est par les présentes donné que le Collège des Médecins et Chirurgiens de la province de Québec demandera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi l'autorisant à payer une pension viagère à son régistraire et à ses employés.Montréal, 24 novembre 1954.L'Avocat du requérant.38725-49-4-0 JEAN TRUDEL.AVIS PUBLIC Demande à la législature Avis est par les présentes donné que les Révérends Pères Roger Pérusse, Lorenzo Picher, Henri Meek, Bernard Bisson et Roger Gendreau, membres de la congrégation des Religieux du Très Saint-Sacrement s'adresseront à la législature de Québec, au cours de la présente session, pour l'obtention d'un projet de loi à l'effet de les constituer en corporation sous le nom de \"Congrégation du Très Saint-Sacrement\", sous certaines conditions.Québec, ce 25 novembre 1954.Les Procureurs des requérants, DORION, DORION & DOYON.38720-49-4-o AVIS Avis est par les présentes donné que The Children's Memorial Hospital des cité et district de Montréal s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi pour changer son nom en celui de \"The Montreal Children's Hospital\", pour être investi des propriétés, droits, pouvoirs et privilèges de Montreal Children's Hospital et, poui d'autres fins.Montreal, le 25 novembre 1954.The Children's Memorial Hospital, Par le Président, 38727-49-4-0 JOHN H.MOLSON.AVIS Avis est par les présentes donné que la Corporation des Pères Bénédictins de Saint-Benoit-du-Lac s'adressera à la Législature de la province de Québec à sa présente session pour demander l'adoption d'une loi modifiant son nom corporatif, étendant ses pouvoirs et ceux de ses membres, étendant le territoire de la Municipalité de Saint-Benoit-du-Lac et les pouvoirs de cette corporation.Saint-Benoit-du-Lac, le 3 novembre 1953.Le Procureur de la pétitionnaire, 38780-50-4-o IVAN SABOURIN.session, praving for the adoption of an Act to decree that'lots No.505, 507 and 509 to 515 inclusive, of the official cadastre for the parish of St-Laurent, in the county of Jacques-Catier, form and have always formed part of the school, municipality of La Côte de Notre-Dame de Liesse, in the county of Jacques-Cartier, and that the school taxes already collected by the school commissioners of the said school corporation have been legally collected and the said commissioners are authorized to retain the same.Montreal, November 18th, 1954.HENRI COURTEMANCHE, 38701-48-4-o Attorney for the plaintiff.NOTICE OF PRIVATE BILL Notice is hereby that the College of the Physicians and Surgeons of the Province of Quebec will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an Act for the authorisation to pay a life annuity to its registrar and to its employees.Montreal, November 24th, 1954.JEAN TRUDEL, 3S725-49-4 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Application to the legislature Notice is hereby given that the Reverend Fathers Roger Pérusse, Lorenzo Picher, Henri Meek, Bernard Bisson and Roger Gendreau, members of the religious congregation of the Blessed Sacrement will apply to the legislature of Quebec, at its present session, to obtain the adoption of a draft bill in order to constitute them as a corporation under the name of \"Congrégation du Très Saint-Sacrement\", with certain conditions.Quebec, November 25th, 1954.DORION, DORION & DOYON, 38720-49-4 Attorneys for the petitioners.NOTICE Notice is hereby given that The Children's Mémorial Hospital of the city and district of Montreal will apply to the legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an Act to change its name to \"The Montreal Children's Hospital\", to vest in it the property, rights, powers and privileges of Montreal Children's Hospital and for other purposes.Montreal, November 25th, 1954.The Children's Memorial Hospital, By: JOHN H.MOLSON, 38727-49-4 President.NOTICE Public notice is hereby given that la Corporation des Pères Bénédictins de Saint-Benoit-du-Lac will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its current session for the adoption of a law modifying its corporate name, increasing its powers and those of its members, increasing the territory of the Municipality of Saint-Benoit-du-Lac and the powers of this Corporation.Saint-Benoit-du-Lac, 3rd November 1954.IVAN SABOURIN, 38780-50-4-o Attorney for the petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1964, V ol.80, No.61 377V Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Avis est, par les présentes, donné que la Corporation de \"Les Frères de la Charité\", corporation ayant son bureau-chef dans les cité et district de Montréal, fera une demande à la Législation de la province de Québec à sa présente session aux fins de faire adopter une loi pour augmenter son pouvoir de posséder des immeubles et pour d'autres fins.Montréal, ce 1er décembre 1954.Le Procureur de la requérante, 38781-50-4-o PHILIPPE FERLAND, C.R., AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que la corporation de la ville d'Àrthabaska, les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Arthabaskaville, la corporation du village de Princcville, les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Princeville, la corporation du village de Warwick et les commissaires d'écoles pour le village de Warwick, tous du comté d'Arthabaska, s'adresseront à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi aux fins suivantes: 1° Autoriser l'imposition d'une taxe de vente de 2% et d'une taxe d'éducation de 1% dans leurs territoires respectifs; 2°.Additionner le produit «les susdites taxes perçues dans les territoires sus-mentionnés et des taxes identiques perçues dans la ville de Victoriaville et en partager le total dans une proportion à être établie entre les différentes parties en cause; 3° Autoriser la ville d'Arthabaska, la corporation du ville de Princeville et la corporation du village de Warwick à emprunter respectivement des sommes de §75,000.00, $75,000.00 et $150,000.00 pour expansion industrielle; 4° Autoriser la ville d'Arthabaska à effectuer pour fins de publicité, d'annonces, de représentation du maire et des échevins une somme n'excédant pas $1,000.00 annuellement; 5° Autoriser le conseil municipal d'Arthabaska à octroyer des deniers jusqu'à concurrence de $1,000.00 annuellement pour aider, dans la ville, certaines sociétés, organisations et œuvres sans but lucratif, et pour autres fins.Arthabaska, P.Q., 18 novembre 1954.Les Procureurs des requérants, WALSH & MOISAN.L'Avocat-adjoint, 38803-50-4-o LOUIS LANGLOIS, C.R., AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la \"Commission des Écoles catholiques de Montréal\" demandera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi en vue d'accroître les pouvoirs de la Commission ayant trait à l'établissement ou à la modification d'assurances collectives ou autres en faveur de certaines personnes; d'amender les dispositions de sa charte relatives à son fonds de dotation; de modifier les dispositions de sa charte ayant trait au fonds de pension de ses employés; de déterminer la mise en vigueur de certains règlements municipaux à l'égard de la construction des écoles; d'autoriser, pour les fins de la taxe scolaire, l'inscription des mutations de Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Notice is hereby given that the Corporation of \"Les Frères de la Charité\", corporation having its head office in the city aud district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the purposes of adopting an act to increase its power to possess immoveables and for other purposes.Montreal, December 1st, 1954.PHILIPPE FERLAND, Q.C., 38781-50-4 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the corporation of the town of Arthabaska and the School commissioners for the municipality of the village of Arthabaskaville, the corporation of the village of Princeville, the School commissioners for the municipality of the village of Princeville, the corporation of the village of Warwick, and the School commissioners for the municipality of the village of Warwick, all of the county of Arthabaska, will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act, for the following purposes: 1.To authorize the imposition of a sales tax of 2% and of an Education tax of 1% in their respective territories; 2.To add the product of these collected taxes in the abovementioned territories and of the same identical taxes collected in the town of Victoriaville, and to sliare the total thereof in the proportion to be made between the several parties in issue.3.To authorize the town of Arthabaska, the corporation of the village of Princeville and the corporation of the village of Warwick to borrow respectively the amounts of $75,000.00, $75,000.00 and 8150,000.00 for industrial expansion; 4.To authorize the town of Arthabaska to grant annually a sum not exceeding $1,000.00 for publicity and advertisement purposes, and to pay entertainment expenses of mayor and councillors.5.To authorize the municipal council of Arthabaska to grant moneys to the amount of $1,000.00 annually to help certain non-profit associations, organizations and works, within the town; and for other purposes.Arthabaska, P.Q., november 18th, 1954.WALSH & MOISAN, Attorneys for the petitioners.LOUIS LANGLOIS, Q.C., 38803-50-4-o Associate Attorney.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the \"Montreal Catholic School Commission\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act to increase the powers of the Commission concerning the establishment and the modification of group insurances or other insurances in favour of certain people; to amend the provisions of its charter concerning its endowment fund; to modify the provisions of its charter concerning the pension fund for its employees; to determine the coining into force of the municipal building by-laws with respect to the erection of schools; for the purpose of the school tax to authorize the inscription of the changes of ownership 3780 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 18 décembre 1964, Tome 86, N° 51 propriétés au rôle de la cité de Montréal; et pour d'autres fins.Montréal, ce 10 décembre 1054.Le Procureur de la Commission des Écoles Catholiques de Montréal, 38829-51-4-o GASTON POULIOT.Cité de Hull Avis est.par les présentes, donné que la \"cité de Hull\", s'adressera à la Législature de la Province de Québec, lors de sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale, amendant sa charte, pour les fins suivantes: pour permettre l'amendement de son règlement de construction et de zonage sans referendum populaire durant sa première année d'existence; pour accorder des subventions dans certains cas particuliers; pour acquérir -des immeubles pour fins industrielles; et pour d'autres fins.Hull, le 7 décembre 1954.Le Maire, (Signé) ALEXIS CARON.Le Greffier, (Signé) II.LÉON LEBLANC.Contresigné : Le Procureur de la cité de Hull, 38830-51-4-o ROY FOURNIER.AVIS Avis par les présentes est donné que les Commissaires d'Écoles pour la municipalité scolaire du village de Cap Chat, et les Commissaires d'Écoles pour la municipalité scolaire de Ste-Annc des Monts village, s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à la présente session, pour obtenir la passation d'une Loi les autorisant à imposer une taxe spéciale de vente de 2%, dans leur territoire respectif.La commission scolaire du village de Cap Chat.Far le Secrétaire-trésorier, FRANÇOIS GAGNON.La Commission scolaire de Ste-Annc des Monts village.Par le Secrétaire-trésorier, LOUIS-PHILIPPE LANGE LIER.38850-51-4-o Actions en séparation de biens Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 364,069.Dame Liesel Mayer, demanderesse, vs Emmanuel Margolis, défendeur.Dame Liesel Mayer, des cité et district de Montréal, épouse commune en bien d'Emmanuel Margolis, agent d'immeubles, du môme lieu, a intenté une action en séparation de biens contre son époux.Montréal, 29 novembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, 38820 (Signé) LÉO D.LAVUT.Canada, province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 364,123.Dame Jeannette Bouffard, épeuse commune en biens de Henri Monette.de Dorval, district de Montréal, demanderesse, Henri Monette, de Dorval, district de Montréal, défendeur.on the roll of the city of Montreal; and for other purposes.Montreal.December 10th, 1954.GASTON POULIOT, Attorney for the Montreal 38829-5l-4-o Catholic School Commission.City of Hull Notice is hereby given that the \"city of Hull\" will present a petition to the Legislature of the Province of Quebec, at is present session, to obtain the adoption of a special law, amending its charter, for the following purposes: to amend its building and zoning by-law without public referendum during its first year of existence; to make grants in certain cases; to acquire immovables for industrial purposes; and for other purposes.Hull, December 7th, 1954.(Signed) ALEXIS CARON, Mayor.(Signed) H.LÉON LEBLANC, City Clerk.Contersigned : ROY FOURNIER, 38830-51-4-o Attorney for the city of Hull.NOTICE Notice is hereby given that the School Commissioners for the School Municipality of the village of Cap Chat, and the School Commissioners for the School municipality of St.Anne des Monts village, will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, to obtain the passing of an Act authorizing them to impose a special sales tax of 2%, in their -respective territories.The School Commission of the village of Cap Chat, Per: FRANÇOIS GAGNON, Secretary-Treasurer.The School Commission of St.Anne des Monts village.Per: LOUIS-PHILIPPE LANGELIER, Secretary-Treasurer.38850-51-4 Actions for separation as to property Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.364,009.Dame Liesel Mayer, plaintiff, vs Emmanuel Margolis.defen-ant.Dame Liesel Mayer, of the city and district of Montreal, wife common as to property of Emmanuel Margolis, Real Estate, agent, of the same place, has instituted and action for separation as to property against her husband.Montreal, November 29th, 1954.(Signed) LÉO D.LAVUT, 38820-o Attorney for the plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.364, 123.Dame Jeannette Bouffard, wife common as to property of Henri Monette, of Dorval, District of Montreal, plaintiff vs Henri Monette, of Dorval, District of Montreal, Defendant. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1951, \\ ol.86, No.51 3781 Avis d'une action en iéparation de biens Dame Jeannette Bouffard, épouse de Henri Monette, chauffeur de taxi, demeurant à Dorval, district de Montréal, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Montréal, le 7 décembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, 38837-o MARIO DU MESNIL.Province de Québec, district d'Iberville, Cour Supérieure, N° 8177.Dame Armande Boulais, demanderesse, vs C.E.Bruchési, en sa qualité de curateur à Albini Bourgeois, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée en cette cause, Montréal, le 14 décembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, 38844-0 BENOIT GONTHIER.Notice of an action on separation as to propertt Dame Jeannette Bouffard, wife of Henri Monette, Taxi Driver, residing at Dorval, District of Montreal, has instituted against her husband an action in separation at to property.Montreal, December 7th, 1954.MARIO DU MESNIL, 38837 .Attorney for plaintiff.Province of Quebec, district of Iberville, Superior Court, No.8177.Dame Armande Boulais, plaintiff, vs C.E.Bruchési, in is quality of curator to Albini Bourgeois, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this case.Montreal, December 14th, 1954.BENOIT GONTHIER, 38844-0 Attorney for the plaintiff.Arrêté en Conseils ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1236 Québec.le 15 décembre 1954.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une convention collective de travail relative à l'industrie de la fabrication des produits de métal en feuilles dans l'Ile de Montréal et un rayon de quinze (15) milles de ses limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La Chambre de Construction Inc., section de la fabrication en métal en feuilles; Et, d'autre part: \"The Sheet Metal Workers Internation il Association, Local 116\"; pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, éditions des 30 octobre et 6 novembre 1954; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans l'industrie* et les métiers visés et la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête; Attendu que les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable M inistre du Travail: Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements) avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1236 Quebec, December 15th, 1954.Present: The Lieutenant Governor in Council Concerning a collective labour agreement relating to the sheet metal products fabricating industry in the Island of Montreal and a radius of fifteen (15) miles from its limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: The Builders' Exchange Inc.(Sheet Metal Fabricating Section), And, on the other part: Sheet Metal Workers International Association, Local Union No.116, for the employers and the employees of the industry and the trades concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette, issues of October 3Cth and November 6th, 1954; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance towards the establishing of working conditions in the industry and the trades concerned and in the territorial jurisdiction indicated in the said petition; Whereas the provisions of the Act have been duly observed as regards the publication of notices; Whereas the objection set forth has been duly considered, as required by the Act; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said petition be accepted in pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments) -with, however, the following new provisions to be substituted for the con- 3782 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 des conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, éditions dee 30 octobre et 6 novembre 1954.I.\u2014 Définitions: Pour les fins d'application du décret les mots et termes suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: a) Le terme \"chef d'équipe\" désigne un mécanicien chargé de l'exécution d'un travail et qui a un groupe de salariés travaillant sous sa juridiction.b) Le terme \"mécanicien en métatl en feuille\" désigne tout salarié qualifié qui peut lire les plans et exécuter d'après les dessins, toute opération relative à là fabrication du métal en feuille et des métaux similaires, sans aide ou surveillance.c) Soudeurs: 1° Le terme \"compagnon-soudeur\" désigne tout salarié possédant une connaissance complète de la soudure acétylène ou électrique de tout métal en feuille ou des métaux similaires et pouvant exécuter lui-môme, d'après les plans et devis, toutes les opérations de son métier, sans aide ou surveillance.Note: Un soudeur qualifié en vertu de l'article 25 des règlements en exécution de la Loi des appareils sous pressions et approuvés par le \"Un fi red Pressure Vessels Code, édition 1943\", doit être considéré comme un compagnon-soudeur.2° Le terme \"soudeur-spécialiste\" désigne un salarié possédant une connaissance de la soudure acétylène ou de la soudure électrique du métal en feuille et des métaux similaires et pouvant, exécuter les opérations de son métier selon les instructions qu'il reçoit.3° Le terme \"soudeur en série\" désigne tout salarié affecté à un travail de routine en soudure dont le taux de salaire est automatiquement majoré de la façon indiquée à l'article VII et qui est promu soudeur spécialiste après le 4ème semestre d'emploi.d) Machiniste: 1° Le terme \"compagnon machiniste\" désigne tout salarié qualifié possédant une connaissance complète de la machinerie et pouvant exécuter sur plans et devis toutes les opérations de son métier.2° Le terme \"machiniste-spécialiste\" désigne un salarié possédant une connaissance complète de la machinerie et qui peut ajuster et voir au fonctionnement de l'une des machines suivantes employées dans l'atelier: tour, fraiseuse, scie (do-all), machine à meuler, raboteur, machine à profiler et à façonner (à l'exception des machines manuelles et des machines d'établi).Il doit être capable de travailler sur plans et devis et savoir se servir de la règle et du micromètre.c) Le mot \"outilleur\" désigne tout salarié spécialisé clans la fabrication des poinçons, guides et outils.L'outillcur doit être capable de produire ces articles d'après les dessins ou esquisses en employant l'outillage régulier de l'atelier, sans aide ou surveillance./) Le terme \"compagnon peintre\" désigne un salarié qui a toute l'expérience voulue pour peinturer les métaux et autres matériaux de même nature, soit au pinceau, au pistolet ou par immersion et pour faire le nettoyage et la cuisson nécessaire.Il doit pouvoir préparer les couleurs et mélanger sa propre peinture et avoir été engagé spécifiquement comme peintre.g) Le terme \"peintre au pistolet\" désigne tout salarié travaillant durant au moins 70% de son temps à peinturer au pistolet et qui peut mélanger la peinture utilisée pour cette opération et prendre soin du pistolet.^ h) Le mot \"forgeron\" désigne tout salarié capable d'exécuter le travail appartenant au métier de forgeron.i) Les mots \"préposé aux machines\" désignent tout salarié capable de monter et d'ajuster sa ditions described in the Quebec Official Ganette, issues of October 30th and November 6th, 1954.1.Definition: For the purpose of enforcement of this decree, the following terms shall have the meaning hereinafter stated: a) \"Charge Hand\" shall mean a mechanic in charge of the fabrication of a job and having a group of men working under his direction.'b) \"Sheet Metal Mechanic\" shall mean an employee skilled in his trade, competent to work from drawings and carry out the fabrication of sheet metal and allied materials products without direction from others.c) Welders: 1.A \"journeyman welder\" shall be an employee with complete knowledge of either gas or electric arc welding of all sheet metal and allied materials, competent to work directly from drawings and specifications and able to carry out.operations in his trade without direction from others.Note: A welder qualified under article 25 of the regulations for carrying out the Pressure Vessels Act and as approved under the \"Unfircd Pressure Vessels Code, 1943 Edition\" shall be classified as a journeyman welder.2.\"Welder Specialist\" shall be an employee with knowdedge of either gas or electric arc welding of sheet metal and allied materials and competent to carry out operations in his trade under supervision.3.A \"Production Welder\" shall be a workman \u2022 employed on routine welding operations, whose rates shall be increased automatically as indicated in section VII, and who shall graduate as a welding specialist after the 4th six months of his employment.d) Machinist: 1.\"Journeyman Machinist\" shall be an employee with full knowledge of machine shop practice, competent to work from drawings and specifications and able to carry out all operations of his trade.2.A \"Machinist Specialist\" shall be an employee with a thorough knowledge of machine shop practice, and able to set up and perform work on one of the major machines used in machine shop work, such as lathe, milling, Do-All, grinder, planer, shapcr, boring mill, (except hand and bench machines.) He shall also be able to work from drawings, and know the scale and micrometer reading.e) A \"Toolmaker\" shall be an employee engaged in the fabricating of dies, jigs and tools.He shall be capable of producing them from working drawings, or sketches, using standard tool room equipment, without direction from others./) A \"Journeyman Painter\" shall be an employee thoroughly experienced in painting metal and allied materials by brush, spray and dipping methods, and in the cleaning and baking procedure necessary.He shall be competent to blend colours and mix his own paint, and shall have been employed specifically as a painter.g) A \"Spray Painter\" shall be an employee engaged a minimum of 70% of his time in spray painting and capable of mixing the paint to be used in said operation and of taking care of the spray gun.h) A \"Blacksmith\" shall be an employee capable of doing the usual work appertaining to the trade of blacksmith.i) A \"Machine Operator\" shall be an employee competent to set up and adjust his machine for QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 3783 machine pour les opérations ordinaires à exécuter et de voir au fonctionnement de sa machine d'une façon compétente.Les préposés à la cisaille mécanique, a la plieuse et découpeuse mécanique ou à la machine à roulet (roll forming) à l'exception de la machine à ourler (lock former) Pittsburg sont considérés comme préposés aux machines.j) Les mots \"assembleur et ouvrier spécialisé\" désignent tous salariés qui peuvent exécuter toute opération d'après les instructions, lire les détails apparaissant sur les plans et exécuter des travaux requérant moins de compétence que ceux qu'exécutent les ouvriers qualifiés.k) Le terme \"ouvrier de la production\" désigne tout salarié qui, ayant reçu l'entraînement nécessaire, exécute du travail ayant trait à la fabrication en série, lequel requiert moins d'expérience que celui des assembleurs et ouvriers spécialisés; tel salarié n'est pas requis de lire les détails sur les plans.Par \"fabrication en série\", on entend une fabrication qui nécessite la répétition des mômes opérations plusieurs fois durant la même journée./) Le terme \"chef de groupe\" désigne tout salarié qui n'est pas un mécanicien et qui est chargé de la direction d'un groupe d'hommes en vue de l'exécution d'instructions déterminées tombant sous le coup de sa propre classification *bu d'une classification inférieure.m) Aides: Les aides sont des salariés qui assistent et qui aident les ouvriers qualifiés appartenant à une classification supérieure à celle des ouvriers de la production.n) Apprentis: Les apprentis sont des garçons ou jeunes gens de 16 à 21 ans; ils reçoivent un carnet d'apprentissage du Comité paritaire.Ce carnet doit être dûment rempli par les employeurs avec mention des périodes de travail dans le métier.o) Garçons: Les garçons de 16 à 18 ans inclusivement peuvent être affectés à un travail de routine, aux taux établis pour les apprentis dans le paragraphe \"t\" de l'article VII, jusqu'à ce qu'ils atteignent le taux régulier des aides.Par travail de routine, on entend le travail des messagers, des commissionnaires ou autre occupation de semblable nature.Si un garçon est placé dans une autre classification, il doit être rémunéré en conséquence.Les garçons autres que ceux affectés à un travail de routine ne peuvent, toutefois, dépasser en nombre le cinquantième des salariés de l'établissement.p) Divers: Les salariés employés régulièrement comme expéditeurs, hommes d'entrepôts ou magasiniers doivent recevoir $0.05 l'heure de plus que le taux minimum des aides.Le salarié en charge de ces départements doit recevoir SO.15 l'heure de plus que le taux minimum des aides.Toutefois, les salariés employés temporairement à ces fonctions continuent de recevoir leurs taux réguliers de salaire.q) Le terme \"polisseur classe \"A\", désigne un salarié qui polit les métaux et alliages de formes variées sans en altérer la forme et les contours; prépare les colles et autres bases adhérentes, choisit les différents abrasifs; forme et ajuste les meules en vue d'obtenir un rendement uniforme.II.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret, comprend l'Ile de Montréal et un rayon de quinze (15) milles de ses limites.III.Juridiction industrielle et professionnelle: a) Le décret s'applique à tous les établissements ordinary operations to be performed and to operate his machine in a skillful manner.Workmen who operate a power shear, power brake or roll forming machine (with the exception of Pittsburg Lock Former) shall be classified as a machine operator.j) \"Assemblers and Specialists\" shall be employees competent to carry out operations oc-cording to instructions, and shall be able to read detailed drawings and engage in work not requiring the skill of a journeyman./.\u2022) \"Production Workers\" shall be employees occupied under supervision in repetitive work that requires less skill than the qualifications of assemblers and specialists; they shall not be required to read detailed drawings.The words \"repetitive work\" shall mean repeated operations several times a day.I) A \"Leading Hand\" shall be an employee (not a mechanic) in charge of a group of men to carry out specific instructions within the scope of his own or a lesser classification.in) \"Helpers\" shall be employees occupied to help and give useful assistance to a more experienced workman classified above the classification of production workers.n) \"Apprentices\" shall be boys or young men between the ages of sixteen and twenty-one.They shall receive an apprenticeship book from the Joint Committee.Such book shall be properly filled by employers, crediting time worked at the trade.6) \"Hoys\" between the ages of 16 and 18 inclusively may be employed for routine operations at the rate set for apprentices in Section VII \"i\" until such time as they acquire the standard rate for helpers.\"Routine operations\" shall comprise such work as messengers, stock-chasers and the like.If a boy be placed in any other classification he shall be paid accordingly.Boys other than those employed on routine operations may not, however, be employed at a ratio greater than one to every 50 .employees in the plant.p) Miscellaneous: Workmen regularly employed as shippers, warehousemen, or stock keepers shall be paid $0.05 per hour in excess of the helpers' minimum rate.The employee in charge of those départements shall be paid 80.15 per hour in excess of the helpers' minimum rate.However, workmen temporarily employed - as above shall retain their regular rates of pay.q) Class \"A\" Buffer and Polisher\" shall be a workman who polishes and buffs metal and alloys of usual and unusual design and shape, maintains contours and shape within reasonable dimensions, prepares glue or other grain lock, selects various abrasives, heads and balances polishing and abrasive wheels for uniformity of production.* II.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the decree shall comprise the Island of Montreal and a radius of fifteen (15) miles from its limits.> III.Industrial and professional juriscidtion: a) The decree shall apply to all establish- 3784 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N\" 61 «'occupant de la fabrication des produits de métal en feuille, y compris les opérations s'y rapportant.Les produits de métal en feuille comprennent tout matériel usiné ou article fabriqué entièrement ou en majeure partie de métal en feuille d'une épaisseur variant de .0043 de pouce à .1875 de pouce.Le métal en feuille désigne l'acier et le fer ainsi que tout métal non-ferreux ou alliage, soit en ruban, soit en feuille ou sous toute autre forme dans les épaisseurs régies par le décret.b) Le décret ne s'applique pas aux établissements industriels ou aux salariés de ces établissements déjà régis par une convention collective de travail rendue obligatoire par décret en vertu de la Loi de la convention collective; il ne s'applique pas non plus à la fabrication de poêles et fournaises par des fonderies, ni à la construction de navire, d'avions ou à la fabrication des produits suivants: cannettes en métal et ustensiles; chaufferettes et radiateurs électriques; réfrigérateurs et humidificateurs électriques pour usage domestique, lampes, appareils et accessoires électriques.IV.Durée du travail: a) La semaine régulière de travail est de quarante-deux heures et demie (423^).La durée journalière ne doit pas excéder huit heures et demie (814), sans détermination des heures de commencement et de cessation du travail.b) Déductions pour retard: Horloge de présence à la minute: Une déduction de quinze (15) minutes est imposée pour tout retard excédant trois minutes par quart d'heure sur les horloges qui enregistrent les minutes, i.e.pour les retards de quatre (4) à dix-huit (1S) minutes, la déduction est de quinze (15) minutes; pour les retards de dix-neuf (19) à trente-trois (33) minutes, la déduction est d'une demi-heure et ainsi de suite.c) Horloge de présente au dixième d'heure: Dans les établissements où ces horloges sont en usage les salariés doivent poinçonner leur temps dans les six minutes (G) qui précèdent l'heure fixée pour le commencement du travail et dans les six minutes (G) qui suivent la cessation du travail.La déduction imposée pour les retards en regard de ce système est la suivante: quinze (15) minutes pour les retards d'un (1) ou deux (2) points (0-12 minutes) et une demi-heure pour les retards de trois (3) quatre (4) et cinq points (5) (18-24-30 minutes).V.Travail supplémentaire: a) Tout travail exécuté en plus de huit heures et demie (8,4) par jour et tout travail exécuté le samedi est considéré comme du travail supplémentaire.b) Tout travail supplémentaire doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport au salaire régulier.c) Le double du taux de salaire régulier doit être payé pour tout travail exécuté les dimanches et les jours de fête suivants: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, le 24 mai, la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, le jour de Noël, ou tout autre jour désigné par une loi ou un décret pour remplacer l'une des fêtes ci-haut mentionnées.Toutefois, à la demande de la majorité des salariés, dans tout établissement et après entente avec l'employeur concerné, il est permis de remplacer le temps perdu à cause de telles fêtes par un nombre équivalent d'heures de travail rémunérées au taux régulier au cours d'un ou de plusieurs jours convenus mutuellement, avec l'approbation préalable du Comité paritaire intéressé.VI.Congés payés: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, le 24 mai, le Jour de la Saint- ments engaged in the manufacture or fabrication of sheet metal products which shall include all processed material and fabricated articles made entirely or principally from sheet metal of a thickness ranging from .0043 of an inch to .1875 of an inch, including all operations incidental thereto.Sheet metal shall be considered as meaning steel and iron as well at> non-ferrous metals and alloys, whether in strips, sheets or any other form within the thickness specified herein above.b) The decree shall be not apply to industrial establishments and their employees already regulated by a collective labour agreement rendered legal and obligatory by decree issued under the authority of the said Act, nor docs it apply to stoves or furnaces manufactured or fabricated by foundries, the construction of ships, aircraft or the manufacture and fabrication of the following products: cans and ustensils; electric radiators and heaters; domestic electric refrigerators and humidifiers; electric lamps, fixtures ami accessories.IV.Standard working hours: u) The standard working week is one of forty-two hours and a half (42^).The standard working day consists of eight and one half hours (8lA).There shall, however, be no specified hours of starting and finishing.b) Deductions: Clocks punching minutes: Late starting shall be penalized fifteen (15) minutes for lateness in excess of \"three minutes of each quarter of an hour, on clocks which punch in minutes, i.e., for laterness from four to eighteen minutes, the penalty shall be fifteen minutes, from nineteen to thirty-three minutes, the penalty shall be one-half hour, etc.c) Clucks punching in tenths of hours: On time clocks which punch in tenths of an hour, an employee's time must be punched one point (within six minutes) before starting time and one point (six minutes) after quitting time.Lateness on cards punched on these clocks shall be penalized as follows: Employees late one or two tenths of an hour (six to twelve minutes) shall be penalized fifteen minutes; three, four and five tenths (eighteen, twenty-four and thirty minutes) shall be penalized one half hour.V.Overtime: a) All time worked in excess of eight and one half (814) hours in any one day and all time worked on Saturday shall be considered as overtime.b) Overtime shall be paid at the rate of time and one half of the regular\" hourly rates.c) Double time shall be paid for all work on Sundays and the following statutory holidays: New Year's Day, Good Friday, May 24, St.Jean-Baptiste Day, Confederation Day, Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day or the day designated by Statute or Decree to be observed as one of the above holidays.However, if requested by the majority of em- \u2022 ployees in any establishment and with, the agreement of the employer concerned, it shall be permissible to substitute an equivalent number of hours to be worked at regular rates on some other day or days to be mutually agreed upon, with the approval in advance of the appropriate Joint Committee.VI.Paid holidays: New Year's Day, Good Friday, May 24, St.Jean-Baptiste Day, Con- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.61 3785 Jean-Baptiste, la Confédération, la Fête du Travail, le Jour d'Action de Grâces et Ncël, sont des congés payés aux taux réguliers aux conditions suivantes: o) i.Lorsqu'un desdits jours de fête tombe un dimanche, le lundi suivant doit être observé comme un jour de congé payé.ii.Lorsqu'un des jours de congé tombe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, la rémunération est celle d'une journée de travail au taux régulier de salaire.' b) Pour avoir droit aux congés, les salariés doivent avoir été au service de l'employeur depuis au moins 30 jours.c) Pour avoir droit à la rémunération, il faut de plus, que les salariés ne soient pas absents le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le congé, exception faite, cependant «les absences causées par: a) un décès dans la famille même du salarié; b) la maladie; c) une permission écrite de l'employeur; et d) la partipation à un jury.d) Les salariés requis de travailler l'un des jours ci-haut mentionnés doivent recevoir une journée complète de salaire au taux régulier en plus de la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils avaient chômé.VII.Salaires minima: Les taux minima de salaires suivants s'appliquent aux catégories de salariés ci-après énumérés.Aucune des dispositions du décret ne peut avoir pour effet de réduire les taux horaires des salariés actuellement en vigueur.Classifications: Taux a) Compagnons: Horaires Mécanicien en métal en feuille.SI.69 Chef d'équipe.1.74 Compagnon soudeur.1.69 Soudeur spécialiste.' 1.48 Soudeur en série : Premier semestre.1.22 Deuxième semestre.1.28 Troisième semestre.1.35 Quatrième semestre \u2022 \u2022 \u2022 \u2022.1 40 Subséquemment, ils deviennent soudeurs spécialistes au taux de 81.48 l'heure.Polisseur, class \"A\".1.55 Machiniste-spécialiste.1.48 Compagnon machiniste.1.69 Outillcur.1.74 Peintre____.1.59 Peintre au pistolet.1.41 b) Forgeron.1.61 c) Préposé au fonctionnement des ma- chines.1.40 d) Assembleur et ouvrier spécialisé.1.48 e) Ouvrier de la production.1.25 Ouvrier de la production après une année de service chez la même employeur .1.30 /) Aide.1.20 g) Chefs de groupe: Les chefs de groupe doivent recevoir 80.10 l'heure de plus que le minimum établi dans le décret pour leur classification.Les aides qui ont atteint lè taux de 81.25 l'heure peuvent être employés régulièrement comme ouvrier de la production, si l'employeur peut le faire.h) Les apprentis tôliers doivent être rémunérés sur la base suivante: Première année: 50% du taux du mécanicien.Deuxième année : 60% du taux du mécanicien.Troisième année: 70% du taux du mécanicien.Quatrième année: 85% du taux du mécanicien.federation Day, Labour Day, Thanksgiving Day and Christmas Day shall be holidays with pay at regular rates: a) i.When a paid Holiday falls on Sunday, the following Monday shall be declared a holiday with pay: ii.Payment shall be made for one standard work day at current rate of pay, if such holiday falls on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday.b) Employees must have been in the service of the employer at least 30 days to qualify.c) Employees must not be absent on the work days immediately preceding .and following the Statutory Holiday in order to qualify for payment, exceptions being made for absence due to: a) death in the immediate family; b) illness; c) written permission from the employer; and d) Jury Duty.d) Employees required to work on any of the abovementioned holidays shall be paid a full day's pay at regular rates and in addition shall receive the holiday pay that would be paid to them if they had not been employed.VII.Minimum wage rates: The following minimum wage rates shall apply to the respective classes of employment hereunder specified.None of the provisions of the decree shall have the effect of reducing any employee's hourly rate now in force.Classifications Hourly a) Journeymen: rates Sheet metal mechanic.SI .69 Charge hand.1.74 Journeyman welder.1.69 Welder specialist.1.48 Production welder: First six months.1.22 Second six months.1.28 Third six months.1.35 Fourth six months.1.40 They then become-welder specialists at 81.48 per hour.Buffer and polisher Class \"A\".1.55 Machinist specialist.1.48 Machinist journeyman.1.69 Toolmaker.1.74 Painter.1.59 Painter (spray).1.41 b) Blacksmith.1.61 c) Machine operator.1.40 d) Assembler and specialist.1.48 c) Production worker.1.25 Production worker (after 1 year's service with same employer).1.30 /) Helper.1.20 g) Leading hands: Leading hands shall receive SO.10 per hour more than the minimum determined in the decree for their classification.Helpers who have attained a wage of S 1.25 on hour may be employed regularly as production workers if the employer can arrange accordingly.h) Apprentice sheet metal mechanics shall be paid on the following basis: First year: 50% of the sheet metal mechanic's rate.Second year: 60% of the sheet metal mechanic's rate.Third year: 70% of the sheet metal mechanic's rate.Fourth year: 85% of the sheet metal mechanic's rate. 3786 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÊBUC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 i) Les garçons de 16 à 18 ans commencent à $0.80 l'heure et reçoivent une augmentation de $0.05 l'heure après chaque semestre de travail ininterrompu.Toutefois, lorsqu'ils atteignent leur 19ème année, ils doivent être classifies comme aides et rémunérés comme tels.Taux j) Divers: Horaires Conducteur de camion, magasinier, homme d'entrepôt, préposé à l'expédition et à la réception des marchandises.SI .25 k) Les salariés faisant partie des équipes de nuit doivent recevoir 80.07 l'heure de plus que les taux ci-haut mentionnés.VIII.Taux pour équipes irrégulières: Un boni de cinq cents (0.05) l'heure doit être payé aux salariés des équipes irrégulières pourvu que la majeure partie du temps consacré à ces équipes tombe en dehors des heures régulières du travail quotidien de l'établissement ou de l'atelier visé.IX.Vacances payées: a) Tous les salariés qui ont cinq ans (5) ou plus de service pour le même employeur au 1er mai, ont droit à deux semaines de vacances payées à raison de 4% des heures régulières effectuées durant, les 12 mois précédents, du 1er mai au 30 avril, au taux en vigueur le 1er juillet si les vacances sont prises après cette date, ou au taux en vigueur avant le 1er juillet si elles sont prises avant cette date.b) Tous les salariés qui ont un an ou plus de service pour le même employeur au 1er mai, ont droit à une semaine de vacances payées à raison de 2% des heures régulières affectuées durant les 12 mois précédents, du 1er mai au 30 avril, au taux en vigueur le 1er juillet si les vacances sont prises après cette date, ou au taux en vigueur avant le 1er juillet si elles sont prises avant cette date.c) Tous les salariés qui ont moins d'un an de service pour le même employeur au 1er niai, ont droit à une rémunération de vacances équivalente à 2% des heures régulières affectuées pendant la période comprise entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année courante, au taux en vigueur le 1er juillet si les vacances sont prises après cette date, ou au taux en vigueur avant le 1 er juillet si elles sont prises avant cette date.- d) A la cessation de leur emploi, les salariés doivent recevoir la rémunération pour vacances à laquelle ils ont droit en vertu des présentes dispositions ainsi que celle qu'ils ont gagné par leur temps de service pendant l'année courante, calculée à compter du 1er mai jusqu'à la date à laquelle ils quittent le service de leur employeur.e) La rémunération de vacances doit être remise au salarié avant son départ en vacances./) L'employeur peut exiger que l'établissement soit fermé pour la période de vacances; il lui est loisible également, d'échelonner les vacances de ses salariés en vue de maintenir un rendement continu.Dans ce dernier cas, il doit s'efforcer de plaire à ses salariés lorsqu'il s'agit de fixer la date de leurs vacances.g) Les vacances doivent être prises entre le premier (1er )mai et le trente (30) septembre.Toutefois, après entente entre l'employeur et le salarié, ce dernier peut prendre ses vacances après le trente (30) septembre.X.Apprentissage: a) La période d'apprentissage est de quatre (4) années; il faut que l'apprenti termine son apprentissage pendant cette période.b) Dans le calcul de cette période de quatre (4) années, tout temps perdu par l'apprenti doit être compensé.A l'expiration de ladite période, t) Boys from 16 to 18 years of age «hall start at $0.80 an hour with increase of five cents an hour every six months of continuous service.However, on attaiuing their 19th year, they shall be classified as helpers and paid as such.Hourly j) Miscellaneous: rates Truck driver, stock and store keeper, warehouseman, shipping and receiving.81.25 k) Employees working on night shifts shall be paid seven cents an hour in excess of the above rates.VIII.Irregular or off shift rates: A premium of five cents an hour shall be paid to all workmen employed on any irregular or off shift provided that the major portion of the time so worked falls outside of the regular daily hours of work of the factory or shop concerned.IX.Vacation with pay: a) All employees who have five or more years service with the same employer at May 1st, sli: II be entitled to two weeks vacation with pay based on 4% of the standard hours worked during the preceding 12 months from May 1st to Anril 30th at the actual wage rate in effect at July 1st or at the time of taking vacation, whichever is the earlier.b) All employees who have one year or more service with the same employer at May 1st, shall be entitled to one week's vacation with pay based on 2% of the standard hours worked during the preceding 12 months from May 1st to April 30th at the actual wage rate in effect at July 1st or at the time of taking vacation whichever is the earlier.c) All employees with less than one year service with the same employer at May 1st shall be entitled to vacation pay based on 2% of the standard hours worked during the period from May 1st of the preceding year to April 30th, of the current year at the actual rate in effect at July 1st of the current year or at the time of taking his vacation whichever is the earlier.d) On termination of employment, all employees shall receive any vacation pay to which they are entitled under this plan plus vacation \u2022 pay which has been earned during the current year by qualified service, calculated from May 1st to the date of leaving the employ of the employer.e) Vacation pay shall be paid previous to the time the employee takes his vacation./) The employer may require the plant to be closed for the purpose of providing a vacation period, or, at his option, may stagger vacation periods of employees so that continuous production may be maintained.In the latter case, the employer shall make every reasonable effort to meet with the wishes of employees in allocating vacation -periods.g) Vacation shall be taken between May 1st and September 30th.However, subject to mutual agreement between the employees and employer, an employee may take his vacation after September 30th.X.Apprenticeship: a) The terra of indenture shall be four years during which period the apprentice should successfully complete his apprenticeship.b) In calculating the four year period, any time lost by the apprentice must be made up.At the end of the four-year period if, in ^îe QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1951, Vol.86, No.51 3787 \u2022i, selon l'employeur, l'apprenti, ne s'est pas qualifié mécanicien, il peut être requis de travailler une période additonnelle ne dépassant pas six (6) mois.c) Il peut y avoir un apprenti tôlier par deux mécaniciens de métal en feuille (tôliers) et la même proportion doit être observée dans le cas des machinistes et apprentis machinistes.d) Les apprentis qui ont fréquenté une école régie par la Loi de l'enseignement spécialisé doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études dans les métiers du métal en feuille et au résultat de leurs examens.XL Retenues: Les retenues sur les salaires, sauf celles requises par la loi, ne sont faites qu'à la suite d'une autorisation écrite du salarié.XII.Classement: Le salarié est classifié par son employeur, lequel soit fournir à chaque salarié une carte de classement convenablement remplie et signée.Cette carte est fournie par le Comité paritaire.Au cas de désaccord, le salarié a l'opportunité de prouver qu'il est compétent pour exécuter le travail de la catégorie pour laquelle il se croit qualifié.XIII.Griefs: Toute mésentente relative au décret et tout grief des salariés sont soumis, par le Comité d'atelier, au surintendant de l'établissement; à défaut d'un règlement satisfaisant, le tout peut être soumis à l'employeur concerné.Dans le cas ou l'employeur et le comité d'atelier ne peuvent s'entendre, le tout est soumis par écrit, au Comité paritaire qui est chargé de la mise à exécution du décret.XIV.Lors de la ratification de la présente convention le Comité paritaire existant, formé pour surveiller l'application du décret antérieur dans la juridiction territoriale déterminée par le présent décret, demeure en fonction et surveille la mise à exécution du présent décret jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé.Ce nouveau coihité succède à l'ancien et est investi de tous les actifs et droits dudit comité; il assume également toutes les dettes de l'ancien comité en vertu du décret antérieur.XV.Durée du décret: Le décret est valable à compter du jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec, et demeure en vigueur pendant une période d'une année (1) après cette date sans reconduction.Le Greffier du Conseil Exécutif, 38855-0 L.DÉSILETS.opinion of the employer, the apprentice has not beccme a qualified mechanic, he may be required to serve additional time not exceeding six months.c) There may be one sheet metal apprentice to every two sheet metal mechanics, and the same ratio shall apply to apprentice machinists and machinists.d) Apprentices who have attended a school under the Specialized Schools Act shall receive a credit in proportion to the duration of their studies in the sheet metal trades and to the result of their examinations.XL Deductions: Deductions from wages except those required by law shall be made only on written authorization of the employee.XII.Rating: The rating of the employees shall be done by the employer who shall furnish each employee with a classification card properly completed and signed.Such cards will be supplied by the Parity Committee.In case of disagreement, the employee concerned shall be given the opportunity to show whether or not he can qualify for the classification which he seeks.XIII.Disputes: All disputes arising under the decree and all grievances of employees, shall be submitted by the Shop Committee to the Superintendent of the Plant concerned and, failing settlement, may be brought before the employer affected.\u2022 Should the employer and the Shop Committee fail to reach agreement, the matter in dispute shall be submitted, in writing, to the Parity Committee administering the decree.XIV.At the time cf ratification of the present agreement, the existing Parity Committee formed to administer the former decree in the territorial jurisdiction determined by the present decree shall ramrin in office and administer the present decree until the formation of a new committee.Such new committee shall succeed the former one and shall be vested with all the assets and rights of the said former committee; it shall kikewise assume all the liabilities of the former committee.XV.Duration of the.decree: The present decree comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remains effective for a period of one year thereafter without reopening.L.DÉSILETS, 38855-0 Clerk of the Executive Council.Avis divers Avis concernant l'aménagement de forces hydrauliques sur la rivière Bazin à 8 milles du village de parent, comté de Laviolette.Miscellaneous Notices Notice concerning the development of hydraulic power of the bazin rlver, at 8 miles distance from the village of Parent, county of Laviolette.Conformément au régime des eaux courantes, In accordance with the Water Course Act, the la corporation du village de Parent cemté de Village Corporation of Parent, county of Lavio-Laviolette, après avoir obtenu, par ordre en lettc, after having obtained by Order in Council conseil du gouvernement de la province de Que- of the Government of the Province of Quebec, bec daté du 21 août 1954, lequel ordre autorise dated August 21st, 1954.which Order authorizes le ministre des Ressources Hydrauliques à louer the Minister of Hydraulic Resources to lease to à la corporation municipale dudit village, les the Municipal Corporation of the said village, forces hydrauliques de la rivière Bazin cantons the hydraulic power resources of the Bazin Landry et Bazin, entre le pont du 8 milles du River, Townships of Landry and Bazin, between chemin qui conduit de Parent à Clova, et la ri- the bridge situate at 8 miles from the road vière Pitchpine, demande au Lieutenant-gouver- leading from Parent to Clova, and the Pitchpine neur en conseil la permission de construire, de River, prays the Lieutenant-Governor in Coun-maintenir et d'exploiter un barrage en béton et cil for permission to build, maintain and develop une usine génératrice d'électricité à environ 200 a concrete dam and electric generating station pieds en amont du site dudit pont.at some 200 feet above the site of said bridge 3788 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 Les originaux des plans et devis ont été déposés au Département des Ressources Hydrauliques de la province de Québec, et- copies des dits plans et devis ont été déposées au bureau de la division d'enregistrement du comté d'Abitibi à Amos.La demande contenue dans cette requête sera prise en considération le ou après les jours suivants la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Québec, le 18 novembre 1954.Les Ingénieurs-Conseil, ZACHÉE & PIERRE LANGLAIS.38779-50-4-o The original plans and specifications have been deposited with the Department of Hydraulic Resources of the Province of Quebec, and copy of said plans and specifications has been deposited at the Registry Office of the Registration Division of the county of Abitibi at Amos.The application contained in this petition will be taken into consideration on or about the days following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Quebec, November 18th, 1954.ZACHÉE & PIERRE LANGLAIS, Consulting Engineers.38779-50-4 AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Hope Baptist Church\", de Hcpetown, Québec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec pour obtenir sa constitution en corporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus de la province de Québec, 1941, et amendements.Montréal, 4 décembre 1954.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231 ouest, rue St-Jacques, Montréal, Que.38778-50-5 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Hope Baptist Church\", of Hopetown, Quebec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and amendments.Montreal, December 4th, 1954.CERINI & JAMIESON, Solicitors for petitioner.231 St.James Street West, Montreal, Que.38778-50-5-o (A.G.6770-53) Burner Equipment Ltd.Règlement XXIV Un règlement augmentant le nombre de directeurs.1° Le nombre des directeurs est, par les présentes, augmenté de trois à cinq.2° Le règlement II de la compagnie est, par les présentes, amendé en remplaçant le mot \"trois par le mot \"cinq\" dans son premier paragraphe.Certifié vraie copie du règlement XXIV de \"Burner Equipment Ltd.\".Daté à Montréal, ce 5e jour de novembre 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 38821 E.IRWIN.Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le deux décembre 1954, le changement de nom de l'\"Association des Policiers de Sherbrooke\", dont la constitution en syndicat professionnel a été autorisée le 13 mai 1950, et dont le siège social est situé à Sherbrooke, dans le district judiciaire de Saint-François, en celui de \"L'Association, des Policiers de Sherbrooke Inc.\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le quatre décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38822-o JEAN BRUCHÉSI.(A.G.6770-53) Burner Equipment Ltd.By-law XXIV A By-law to increase the number of Directors.1.The number of Directors of the company is hereby increased from three to five.2° By-law II of the company is hereby amended by substituting the word \"five\" for the word \"three\" in the first paragraph thereof.Certified true copy of by-law XXIV of \"Burner Equipment Ltd.\".Dated at Montreal, this 5th day of November, 1954.(Seal) E.IRWIN, 38821-0- Secretary.Notice of change of name (Professional Syndicates' Act) Notice is here given that the Honourable the Provincial Secretary has .authorized, on December second, 1954, the change of name of the \"Association des Policiers de Sherbooke\", whose incorporation into a Professional Syndicate was authorized on May 13th, 1950, and whose head office is situate at Sherbrooke, in the judicial district of St.Francis, into that of \"L'Association des Policiers de Sherbrooke Inc.\", and such pursuant to the provisions of articles 7 and the following of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, this fourth day of December, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38822 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 196& Vol.86, No.51 3789 Montréal \u2014 Province de Québec Montréal \u2014 Province of Quebec Avis vous est par les présentes donné que les Notice is hereby given that the following personnes suivantes sont membres de l'Associa- persons are members of the Association of Pro-tion des Chimistes Professionnels de Québec.fessional Chemists of Quebec.D.Pi.Morrison\tShawinigan Falls\tD.R.Morrison\tShawinigan Falls R.V.Nicholls\tMontréal\tR.V.Nicholls\tMontreal B.Ostiguy\tIberville\tB.Ostiguy\tIberville B.Peclet\tMontréal\tB.Peclet\tMontreal R.G.Pitcher\tSt.Laurent\tR.G.Pitcher\tSt.Laurent C.B.Pur'ves\tMontréal\tC.B.Purves\tMontreal J.H.Quastcl\tMontréal\tJ.H.Quastel\tMontreal G.D.Raitt\tLaval sur le Lac\tG, D.Raitt\tLaval sur le Lac M.Rinfret\tMontréal\tM.Rinfret\tMontreal R.Rivest\tMontréal\tR.Rivest\tMontreal A.Roberge\tPlessisville\tA.Roberge\tPlessisville R.M.Rowat\tMontréal\tR.M.Rowat\tMontreal W.Rumsey\tSt.Laurent\tW.Rumsey\tSt.Laurent P.R.Steycrmark\tMontréal\tP.R.Steycrmark\tMontreal H.S.Sutherland\tMontréal\tH.S.Sutherland\tMontreal R.Tardif\tSt.Laurent\tR.Tardif\tSt.Laurent V.H.Vedda\tMontréal\tV.H.Vedda\tMontreal A.Vendette\tMontréal\tA.Vendette\tMontreal F.0.Walkling\tWestmount\tF.0.Walkling T.A.Willis\tWestmount T.A.Willis\tMontréal\t\tMontreal C.A.Winkler\tMontréal\tC.A.Winkler\tMontreal \u2022 A.0.Wolff\tMontréal\tA.0.Wolff\tMontreal S.S.Worthcn\tMontreal\tS.S.Worthen\tMontreal C.H.Young\tWestmount\tC.H.Young\tWestmount R.A.Ayotte\tMontréal\tR.A.Ayotte\tMontreal 0.Bastien\tSaint-Jean\t0.Bastien\tSaint-Jean E.A.W.Boyce\tMontréal\tE.A.W.Boyce\tMontreal Anna V.Brown\tMontréal\tAnna V.Brown\tMoiitreal W.Charnutzky\tMontréal\tW.Charnutzky\tMontreal H.H.Clare\tMontréal\tH.H.Clare\tMontreal J.Dansereau\tMontréal\tJ.Dansereau\tMontreal H.J.Desbarats\tMontréal\tH.J.Desbarats\tMontreal A.S.Dies\tMontréal\tA.S.Dies\tMontreal .1.R.Donald\tMontréal\tJ.R.Donald\tMontreal L.Firing\tMontréal\tL.Firing\tMontreal J.M\".Firth\tMontréal\tJ.M.Firth\tMontreal L.H.Gendron\tMontréal\tL.H.Gendron\tMontreal G.II.Gol lschmied\tMontréal\tG.H.Goldschmied\tMontreal A.Grcybornc\tCowansville\tA.Grcybornc\tCowansville E.Hoffman\tMontréal\tE.Hoffman\tMontreal C.M.Homer\tValois\tC.M.Horncr\tValois A.M.Hurter\tMontréal\tA.M.Hurter\tMontreal R.W.Kolb\tMontréal\tR.W.Kolb\tMontreal J.Kwiatkowski\tMontréal\tJ.Kwiatkowski\tMontreal L.LaFontaine\tMontréal\tL.LaFontaine\tMontreal R.Lavigne\tSaint-Jean\tR.Lavigne\tSaint-Jean A.Labrie\tQuébec\tA.Labrie\tQuebec W.M.MacLean\tStrath more\tW.M.MacLean\tStrathmorc D.M.Matheson\tMontréal\tD.M.Matheson\tMontreal R.D.Morrison\tMontréal\tR.D.Morrison\tMontreal J.K.Mowat\tMontréal\tJ.K.Mowat\tMontreal G.Nadeau\tQuébec\tG.Nadeau\tQuebec A.H.Neufeld\tMontréal\tA.H.Neufled\tMontreal E.Nyman\tMontréal\tE.Nyman\tMontreal B.Rapson W.T.D.Ross\tArvida\tB.Rapson\tArvida \tMontréal\tW.T.D.Ross\tMontreal T.W.Smith\tMontréal\tT.W.Smith\tMontreal J.K.Souch\tVille St.Laurent\tJ.K.Souch\tVille St.Laurent R.Soucy\tMontréal\tR.Soucy\tMontreal B.G.Spracklin L.Ujeski\tMontréal\tB.G.Spracklin\tMontreal \tMontréal .\tL.Ujeski\tMontreal 0.V.Vrany\tMontréal\t0.V.Vrany\tMontreal J.0.C.Wurtele\tSte Thérèse de Bainville\tJ.0.C.Wurtele\tSte.Thérèse de Ba:nville A.Wygnanski\tMontréal\tA.Wygnanski\tMontreal A.H.Anderson\tMontréal\tA.H.Anderson\tMontreal E.D.Bent\tLachine\tE.D.Bent\tLachine A.G.Borduas\tMontréal 1\tA.G.Borduas\tMontreal J.R.Charlton\tMontréal\tJ.R.Charlton\tMontreal C.E.Coke\tMontréal\tC.E.Coke\tMontreal G.Davidson\tMontréal\tG.Davidson\tMontreal L.Delphiner\tMontréal\tL.Delphiner\tMontreal G.J.Emyei\tMontréal\tG.J.Emyei\tMontreal 3790 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 61 F.Gamble G.C.Garrow G.R.Gilbert R.Haworth H.C.Kerman R.Leduc H.G.Littler J.P.McHaffic G.R.Maybec L.J.Morin H.C.Pearson L.J.Sheps C.M.Skinner 38825-o McMasterville Drummondvill» Drummondville Drummondville Montréal Montréal Montréal Québec Montréal Three Rivers Montréal Lachinc \u2022 Montréal Le Secrétaire-régistraire, ARTHUR F.WATSON.F.Gamble G.C.Garrow G.R.Gilbert R.Haworth H.C.Kerman R.Leduc H.G.Littler J.P.McHaffic G.R.Maybec L.J.Morin H.C.Pearson L.J.Sheps C.M.Skinner 38825-0 McMasterville Drummondville Drummondville Drummondville Montreal Montreal Montreal Quebec Montreal Three River.s Montreal Lachine Montreal ARTHUR F.WATSON, Secretary-Registrar.(P.G.11185-54) Cercle des Mycologues Amateurs de Québec v Extrait des règlements de la corporation ci-haut mentionnée, tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 12 mai 1954, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de cinq à huit: \"Article IX \u2014 Conseil d'administration \u20142/ Le conseil d'administration se composera de huit (8) directeurs: Un président; un premier vice-président; un deuxième vice-président; un secrétaire; un trésorier; trois directeurs, dont l'un sera ex-officio le président sortant de charge.\" Certifié vraie copie.Le Président, 38820-o (Signé) C.-A.KIROUAC, M.D.(P.G.11185-54) ., Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procurcur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le sept décembre 1954, les règlements du \"Cercle des Mycologues Amateurs de Québec\", tels «m'adoptes à l'assemblée générale tenue le 12 mai 1954, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le sept décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38826-0 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.111,85-54) Cercle des Mycologues Amateurs de Québec Excerpt of the by-laws of the above mentioned corporation, as adopted at the meeting held on May 12th, 1954, concerning the increase in v number of Directors from five to eight: \"Article IX \u2014 Board of directors\u20142.The administrative council shall be composed of eight (8) Directors: A President; a first Vice-President; a second Vice-President; a Secretary, a Treasurer; three Directors, one of which shall be ex-officio the President leaving office.\" Certified true copy.(Signed) C.-A.KIROUAC, M.D., 38826 President.(P.G.11208-54) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procurcur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le vingt-deux novembre 1954, les règlements généraux de l'\"Association des Marchands Unis par la Radio (A.M.U.R.)\", comprenant les articles 1 à 50 inclusivement, tels qu'adoptés à l'assemblée générale spéciale tenue le 2 novembre 1954, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le onze décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province.38827-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Cartierville\", en date du 14 novembre 1954, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné nu bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-quatre novembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38828-0 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.11185-54) Notice is hereby given that, upon the rccoin-mcntation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary, has approved, on December seve th, 1954, the bylaws of the \"Cercle des Mycologues Amateurs de Québec\", as adopted at thï general meeting on May 12th, 1954, and such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, on December seventh, .1954.JEAN BRUCHÉSI, 3S82G Under Secretary of the Province.(A.G.11208-54) Notice is given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on November twenty-second 1954, the general bylaws of the \"Association des Marchands Unis par la Radio (A.M.U.R.)\", including articles 1 to 50 inclusive, such as adopted at a special general meeting held on November 2nd, 1954, and thus, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the eleventh day of December, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38827 ¦ Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Cartierville\", under date of November 14th, 1954, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-fourth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 88828 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 3791 (P.G.10696-54) Association db Bienfaisance Crémazie Extrait des règlements de la corporation ci-haut mentionnée, tels qu'adoptés à l'assemblée générale tenue le 7 juin 1954, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois (3) à cinq (5) : \"Article 2 \u2014 Bureau de Direction \u2014 a) Les affaires de l'Association sont administrées par un bureau de direction composé de cinq administrateurs, dont un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier et deux directeurs.\" Copie certifiée conforme.Le Secrétaire, 38833-0 CLAUDE LE COLLETER.(P.G.12547-52) Quebecair Inc.Extrait des minutes de l'assemblée spéciale desactionnaires de \"Quebecair Inc.\", dûment convoquée et tenue au siège social de la Compagnie, à 76 Ave de la Cathédrale, à Rimouski, le 22 novembre 1954: \"Proposé par Me Maurice Tessier, secondé par monsieur Henri Jacob et résolu unanimement d'amender les règlements généraux de la Compagnie pour augmenter le nombre des directeurs de cinq à sept (de 5 à 7).\" Certifié vraie copie.Le Vice-président et secrétaire, 38834-0 MAURICE TESSIER.(P.G.3281-51) John R.Anderson & Son Limited Un règlement diminuant le nombre des directeurs de la compagnie de six (0) à cinq (5) : \"En conséquence qu'il soit décrété comme un article révisé des règlements de John R.Anderson & Son Limited que: Les affaires de la compagnie seront administrées par un Conseil d'Administration de cinq directeurs, dont quatre formeront quorum.\" Certifié vraie copie: Le Président, A.1).ANDERSON.Le Sociétaire, 38835 W.A.CLARKE.(P.G.12059-51) Menley & James Company Limited ofCanada Certification d'adoption du règlement augmentant le nombre des directeurs de sept (7) à huit (8).Nous, C.L.Eawell et Cli fford II.Marsh, étant respectivement le Président et Secrétaire de \"Menley & James Company Limited of Canada\", une corporation constituée en vertu de la la Loi des compagnies de Québec (1907), certifiions que le suivant est une vraie copie de la section 2 de l'article II des règlements de ladite compagnie, tels qu'amendés: \"Section 2, Nombre et élection.Le nombre des directeurs qui constitueront tout le bureau de direction sera de huit.Chaque directeur sera un actionnaire possédant au moins une action du capital absolument et en son propre nom et n'aura pas d'arrérages relativement à tout appel sur icelle.Les directeurs seront élus à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, et chaque directeur sera élu pour remplir un terme d'une année et jusqu'à ce qu'un successeur dûment qualifié soit élu.Dans le cas de tout (A.G.10696-54) Association de Bienfaisance Crémazie Excerpt from by-laws of the abovementioned corporation such as they were adopted at a general meeting held on June 7th, 1954, concerning the increasing of the number of directors three (3) to five (5): \"Article 2 \u2014Board of Directors \u2014a) The affairs of the Association shall be managed by a Board of Directors composed of five executives, including one president, one vice-president, a secretary-treasurer and two directors.\" Certified true copy.CLAUDE LE COLLETER, 38S33 Secretary.(A.G.12547-52) Quebecair Inc.Excerpt from minutes of a special meeting of shareholders of \"Quebecair Inc.\", duly called and held at the office of the Company, at 76 de la Cathédrale Avenue, at Rimouski, November 22nd, 1954: \"Proposed by Me Maurice Tessier, seconded by Mr.Henri Jacob and unanimously resolved that the general by-laws of the Company be amended in order to increase the number of directors from five to seven (from 5 to 7).\" Certified true copy.MAURICE TESSIER, 38834 Vice-President and Secretary.(A.G.3281-51) John R.Anderson & Son Limited By-law reducing the number of the Company's Directors from six (6) to five (5): \"Now therefore be it enacted as a Revised Article of the by-laws of John R.Anderson & Son Limited that: The affairs of the Company shall be managed by a Board of five Directors, four of whom shall form a quorum.\" Certified a true copy: A.D.ANDERSON, President.W.A.CLARKE, 38S35-0 Secretary.(A.G.12059-54) Menley & James Company Limited ok Canada Certificate of adoption of by-law increasing the number of directors from seven (7) to eight (8).We, C.L.Fawell and Clifford H.Marsh, being respectively the President and Secretary of \"Menley & James Company Limited of Canada\", a corporation formed under the Quebec Companies' Act (1907), do hereby certify that the following is a true copy of Section 2 of Article II of the by-laws of the said company, as amended : \"Section 2.Number and Election.The number of directors\" which shall constitute the whole board shall be eight.Each director shall be a shareholder owning at least one share of stock absolutely in his own right and not in arrears in respect of any call thereon.The directors shall be elected at the annual general meeting of the shareholders, and each director shall be elected to serve for the term of one year and until a duly qualified successor shall be elected.Whenever any director ceases to be a shareholder, 3792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1951, Tome 86, N° 51 directeur qui cesse d'être un actionnaire, sa place au bureau de direction sera et deviendra vacante immédiatement, et la vacance sera comblée de la manière pourvue ci-après au sujet du remplacement des vacances.\" En foi de quoi, nous avons signé et apposé le sceau de la corporation le 29e jour de juin 1954.(Sceau) 38836 (P.G.9027-52) Le Président, .C.L.FA WELL.Le Secrétaire, CLIFFORD H.MARSH.AVIS Copie certifiée du règlement spécial \"A\" de \"Siderur (Canada) Ltd.\" adopté à une assemblée des directeurs de Siderur (Canada) Ltd., tenue à 2.00 p.m., le 8 octobre 1954, et approuvé, ratifié et confirmé à l'unanimité à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie tenue au siège social le 18 octobre 1954, à 2.30 p.m.Règlement spécial \"A\" Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois à cinq, et que le règlement II des règlements généraux de la compagnie soit et il est, par les présentes, amendé en changeant le mot \"trois\" pour le mot \"cinq\".Vraie copie certifiée.(Sceau) Le Secrécaire, 38838 RONALD TODD CHAMBERS.Avis est.par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Co-op Et-chemin\", en date du 30 novembre 1954, dont le siège social est situé à Sainte-Germaine de Dorchester, dans le comté de Dorchester, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le quinze décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38845-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.11396-54) Trans-Canada Corporation Fund corporaton de valeurs TrANS-CaNADA Règlement N° 22\" Il est déclaré comme règlement de la compagnie ce qui suit: \"Le nombre des directeurs de la compagnie est par les présentes porté de 5 à 11 directeurs dont 5 d'entre eux constitueront quorum.\" Certifié vraie copie, Montréal, ce 8ième jour de novembre 1954.Le Secrétaire, 38846-o ANDRÉ CHARRON.En vertu de l'article 90 de la Loi des Companies de Québec, \"Préfabrication Canadienne Inc.\" donne avis, par les présentes, qu'elle a adopté un règlement pourvoyant à la discontinuation de ses affaires et un règlement autorisant la distribution de ses actifs à ses actionnaires.Québec, le 10 décembre 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 38848-o LÉOPLOD^GLRARD.his place upon the directorate shall be and thereby immediately becomes vacant, and the vacancy shall be filled in the manner hereinafter provided for the filling of vacancies.\" In witness whereof, we have hereunto set our hands and caused the seal of the corporation to be affixed this 29th dav of June, 1954.(Seal) C.L.FA WELL, President.CLIFFORD H.MARSH, 33836-0 Secretary.(A.G.9027-52) NOTICE Certified copy of special by-law \"A\" of \"Siderur (Canada) Ltd.\", adopted at a meeting of directors of Siderur (Canada) Ltd., held at 2.00 p.m., on October 8th., 1954, and unanimously approved, ratified and confirmed at the annual general meeting of sharehol lers of the Company, held at its Head Office on October 18th., 1954, at 2.30 p.m.Special by-laxo \"A\" That the number of Directors of the Company be increased from three to five, and that by-law II of the general by-laws of the Company be and it is hereby amended by changing the word \"three\" to \"five\".s (Seal) RONALD TODD CHAMBERS, 38838 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Co-op Etchemin\", under date of November 30th, 1954, whereof the head office is at Sainte-Germaine de Dorchester, in the county of Dorchester, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fifteenth day of December 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38845 Under Secretary of the Province.(A.G.11396-54) Trans-Canada Corporation Fund Corporation de valeurs Trans-Canada By-law No.22 Be it declared as a by-law of the company as follows: \"The number of directors of the company is hereby increased from 5 to 11 directors, 5 of whom shall constitute a quorum.\" Certified true copy, Montreal, this 8th day of November 1954.ANDRÉ CHARRON, 38846 Secretary.Under the provisons of section 90 of the Quebec Companies' \\ct,^ \"Canadian Préfabrication Inc.\" hereby gives notice that it has approved a By-law whereby this company has ceased to carry on business except for winding-up its affairs and has also approved a by-law for distributing the assets of the company to its shareholders.Quebec, December 10th, 1954.(Seal) LEOPOLD GIRARD, 38848-0 .Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.61 8793 (P.G.11434-54) Dun Raven Mines Limited (No Personal Liability) Règlement N° 6 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Dun Raven Mines Limited\" (No Personal Liability), (ici nommé la \"compagnie\") ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de cinq (5) à sept (7) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de sept (7) directeurs.2.Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3.Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.Décrété ce 20e jour de novembre 1954.Certifié vraie copie.Dun Raven Mines Limited (No Personal Liability) Par le Président, 38852 THOMAS ADAMS.(A.G.12056-54) Kemp Uranium Mines Limited (No Personal Liability) Règlement N° 6 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme le règlement N° 6 de \"Kemp Uranium Mines Limited\" (No Personal Liability), (ci-après nommée la \"compagnie\") ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à cinq de manière que le conseil d'administration de la compagnie soit dorénavant composé de cinq directeurs.2.Deux directeurs formeront quorum à toute assemblée du conseil d'administration.3.Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Décrété ce 24e jour de novembre 1954.Témoin: Le sceau corporatif de la compagnie.Certifié vraie copie.Kemp Uranium Mines Limited (No Personal Liability) Par le Secrétaire, 38853 F.J.STEPHENS.(A.G.11434-54) Dun Raven Mine9 Limited (No Personal Liability) By-law No.6 Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Dun Raven Mines Limited\" (No Personal Liability), (herein called the \"Company\") as follows: 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from five (5)'to seven (7) so that the board of Directors of the company shall hereafter be composed of seven (7) Directors.\"2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 20th day of November, 1954.Certified true copy Dun Raven Mines Limited (No Personal Liability) Per: THOMAS ADAMS, 38852-o President.(A.G.12056-54) Kemp Uranium Mines Limited (No Personal Liability) By-law No.6 Be it enacted and it is hereby enacted as by-law No.6 of \"Kemp Uranium Mines Limited\" (No Personal Liability),, (hereinafter called the \"Company\") as follows: 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three to \"five so that the Board of Directors of the company shall hereafter be composed of five directors.2.Two directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 24th day of November, 1954.Witness: The corporate seal of the company.Certified true copy.Kemp Uranium Mines Limited (No Personal Liability) Per: F.J.STEPHENS, 38853-0 Secretary.Charte \u2014 Abandon de Canadian Trade Fair Catalogues Ltd.Avis est donné que la compagnie \"Canadian Trade Fair Catalogues Ltd.\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social et principal place d'affaires en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 9e jour de décembre 1954.Les Procureurs de \"Canadian Trade Fair Catalogues Ltd.\", LIVERMAN, LIVERMAN & BRISKIN.1435 rue St-Alexandre, Montréal.38823 Charter \u2014 Surrender of Canadian Trade Fair Catalogues Ltd.Notice is hereby given that the \"Canadian Trade Fair Catalogues Ltd.\" a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office and principal place of business in the city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 9th day of December, 1954.LIVERMAN, LIVERMAN & BRISKIN, Attorneys for \"Canadian Trade Fair Catalogues Ltd.\".1435 St.Alexander Street, Montreal.38823-0 3794 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1964, Tome j$0, A70 51 Compagnies dissoutes (P.G.11791-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Stntuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"lîchnar Club Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 27 juin 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du deux novembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12172-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26 et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Adson Corp.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 février 1953.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.9455-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Duricux Entreprises, Incorporée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 janvier 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-o C.E.CANTIN.(P.G.15357-52) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"G.& R.Trading Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 mars 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12526-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plus au Procu- Companies Dissolved (A.G.11791-64) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Belmar Club Inc.\", incorporated by letters patent dated June 27th, 1950.Notice is also given that from and after November second, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12172-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Adson Corp.\", incorporated by letters patent dated February 10th, 1953.Notice is also given that from and after December fifteenth 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.9455-52) v Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Duricux Entreprises, incorporée, incorporated by letters patent dated January 22nd, 1949.Notice is also given that from and after December fifteenth, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December, 1954.C.E.CANTIN, 3S817 Deputy Attorney General.(A.G.15357-52) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"G.& R.Trading Company Limited\", incorporated by letters patent dated March 8th, 1946.Notice is also given that from and after December fifteenth, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December, 1954.CE.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12526-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 195A, Vol.86, No.51 3795 reur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"La Photogravure Artistique, Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 avril 1933.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38S17-0 C.E.CANTIN.(P.G.12383-54) Avis est donné qu'en vertifdc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Laurier Avenue Realty Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 janvier 1947.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procurcur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(P.G.12048-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 270, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Le Club Bellcvue des Trois-Rivièrcs, Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 15 avril 1929.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 3SS17-0 C.E.JSANTIN.(P.G.11155-54) \u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"().Tanguay & Fils, Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 5 mai 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 3S817-0 CE.CANTIN.(P.G.11855-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de-ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Ready Mix Concrete Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 23 juillet 1929.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.surrender of the charter of the company \"La Photogravure Artistique, Ltée\", incorporated by fetters patent dated April 24th, 1933.Notice is also given that from and after December fifteenth , 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December, 1954.C E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12383-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Laurier Avenue Realty Corporation\", incorporated by letters patent dated January,14th, 1947.Notice is also given that from and after December fifteenth 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.12048-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lc Club Bellevuc des Trois-Rivières, Limitée\", incorporated by letters patent dated April 15th, 1929.Notice is also given that from and after the fifteenth day of December 1954; the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December 1954.C E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.11155-54) Notice is hereby given that under Part I of the Qucbce Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"O.Tanguay & Fils, Limitée\", incorporated by letters patent dated May 5th, 1948.Notice is also given that from and after December fifteenth, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1954.C E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.11855-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the s: i 1 Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Ready Mix Concrete Limited\", incorporated by letters patent dated July 23rd, 1929.Notice is also given that from and after December fifteenth, 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General. 3796 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1964, Tome 86, N* 61 (P.G.12676-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Vance Johnson, Limited\", constituée en corporation par lettres pat entes en date du 25 novembre 1930.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 3S817-o C.E.CANTIN.(P.G.11981-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilté décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plus au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Viau Investments Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 19 février 1940.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1954, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38817-0 C.E.CANTIN.(A.G.12676-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Vance Johnson, Limited\", incorpourtcd by letters patent dated November 25th, 1930.Notice is also given that from and after December fifteenth 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December 1954.C.E.CANTIN, 38817 Deputy Attorney General.(A.G.11981-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Viau Investments Limited\", incorporated by ietters patent dated February 19th, 1940.Notice is also given that from and after December fifteenth 1954, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December 1954.C.E.CANTIN, 38S17 Deputy Attorney General.Département de l'Agriculture Avis est donné que, en vertu de la Loi des société agricoles et laitières (S.R.Q.1941, chapitre 123), une société agricole a été constituée sous le nom de \"Association Aberdeen-Angus du Québec \u2014 Quebec Aberdeen-Angus Association\" et que son siège social est à Sherbrooke.Daté du bureau du ministre de l'agriculture ce septième jour de décembre 1954.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 38847-0 R.TRÉPAN 1ER.Department of Agriculture Notice is hereby given that, in conformity with the Farmers' and Dairymen's Associations Act, (R.S.Q.1941, chapter 123), an agricultural association has been formed under the name of \"Association Aberdeen-Angus du Québec \u2014 Quebec Aberdeen-Angus Association\" and that its head office is in Sherbrooke.Dated in the office of the Minister of Agriculture on the seventh day of December 1954.R.TRÉPANIER, 38847 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Instruction Publique N° 552-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Lacolle, dans le comté de St-Jean, le lot 1 du cadastre officiel de la paroisse de St-Valentin, et la partie du lot 426 du même cadastre, bornés au sud par la rivière Lacolle, à l'ouest par la ligne de division entre les lots 426 et 427, au nord par la ligne qui passe dans la Montée Bowman et à l'est par le chemin de fer Canadien National, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Paul-de-LTle-aux-Noix, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38795-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 728-53.Québec, le 7 décembre 1954.Demande est faite d'annexer pour les contribuables protestants seulement, le territoire de la municipalité scolaire du canton East Farn-ham, dans le comté de Brome, à la municipalité scolaire protestante de Cowansville, comté de Missisquoi.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38793-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.552-54.Quebec, December 3rd, 1954.' Application is made to detach from the school municipality of Lacolle, in the county of St-John, lot 1 of the official cadastre of the parish of St-Valentin, and part of lot 426 of the same cadastre, bounded on the south by the Lacolle River, on the west by the dividing line between lots 426 and 427, on the North by the line which passes in the Bowman slope and on the east by the Canadian National Railway, to annex them to the school municipality of St-Paul-de-l'Ilc-aux-Noix, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38795-50-2 Superintendent of Education.No.728-53.Quebec, December 7th, 1954.Application is made to annex for the Protestant ratepayers only, the territory of the school municipality of the Township of East Farnham, in the county of Brome, to the Protestant School Municipality of Cowansville, county of Missisquoi.^ O.J.DÉSAULNIERS, 38793-50-2 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1964, Vol.86, No.51 3797 N° 503-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Francois-Xavier-dc-Bromp-ton, dans le comté de Richmond, les lots 1 à 7 inclusivement du rang 1 et 1 à 17 inclusivement du rang 11 du cadastre officiel de St-François-Xavier-de-Brompton, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire catholique de St-Grégoirc-de Greenlay, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique 38794-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 751-54.Québec, le 2 décembre 1954.Demande est faite d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, le territoire de la municipalité scolaire du village de Dunham, dans le comté de Missisquoi, à celui de la municipalité scolaire protestante «le Cowans-ville, même comté.Le village de Dunham comprend la demie ouest des lois originaires 10, 11 et 12 du rang VI et la demie est des lots originaires 10, 11 et 12 du rang VII du canton Dunham.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38798-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.No.1225-54.Québec, le 3 décembre 1954.Avis est par la présente donné que je me propose d'annexer au territoire actuel de la municipalité scolaire de Rapide Danseur, comté d'Abitibi-Ouesl.tous les lots du rang VI du canton Hébécourt, territoire qui n'est pas pas encore organisé au point de vue scolaire.Le Surintendant de l'Instruction publique, 3S799-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 763-54.Québec, le 2 décembre 1954.Demande est faire d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, le territoire de la municipalité scolaire de Port Daniel-Est, comté de Bonaventure, à la municipalité scolaire protestante de Shigawake de Port Daniel, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38800-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 731-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Adolphe-dc-Dudswell, dans le comté de Wolfe, les lots 13 à 15 inclusivement du rang VII du canton Dudswell, pour les annexer à la municipalité scolaire de Saint-Adol-phe-de-Marbleton, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38801-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.No.767-5-1.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Cranbourne, dans le comté de Dorchester, les lots 20, 24 et 25 du rang I du cadastre officiel de Saint-Odilon-de-Cranbourne, pour les annexer à la municipalité scolaire de Saint-Edouard-de-Frampton-Ouest, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38802-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.No.503-54.Quebec, December 3rd, 1954.Application is made to detach from the school municipality of St-Francois-Xavier-de-Bromp-ton, in the county of Richmond, lots 1 to 7 inclusively of range I and 1 to 17 inclusively of Range II, of the official cadastre of St-François-Xavier-de-Brompton, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the Catholic School Municipality of St-Grégoire de Greenlay, in the same countv.O.J.DÉSAULNIERS, 38794-50-2 Superintendent of Education.No.751-54.Quebec, December 2nd, 1954.Application is made to annex, for Protestant ratepayers only, the territory of the school municipality of the village of Dunham, in the County of Missisquoi, to that of the Protestant school municipality of Cowansville, same county.The village of Dunham includes the westerly half of original lots 10, 11, and 12, range VI, and the easterly half of original lots 10, 11 and 12, range VII, of the township of Dunham.O.J.DÉSAULNIERS, 3879S-50-o Superintendent of Education.No.1225-54.Quebec, December 3rd, 1954.Notice is hereby given that I propose to annex to the present territory of the school municipality of Rapide Danseur, County of Abitibi-West all lots of range VI of the township of Hébécourt, territory which is not as yet organized from an educational point of view.O.J.DÉSAULNIERS, 38799-50-2 Superintendent of Education.No.703-54.Quebec, December 2nd, 1954.Application is made to annex for the Protestant ratepayers only the territory of the school municipality of Port Daniel-East, county of Bonaventure, to the Protestant school municipality of Shiga wake of Port Daniel, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38800-50-2 Superintendent of Education.No.731-54.Quebec, December 3rd,.1954.Application is made to detach from the school municipality of St.Adolphe-de-Dudswcll, in the county of Wilfe, lots 13 to 15 inclusive, range VII of the township of Dudswell, in order to annex them to the school municipality of St.Adolphe-de-Marbleton, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38801-50-2 Superintendent of Education.No.767-54.Quebec, December 3rd, 1954.Application is made to detach from the school municipality of Cranbourne, in the county of Dorchester, lots 20, 24 and 25, range I of the official cadastre of St.Odilon-de-Cranbourne, in order to annex them to the school municipality of St.Édouard-de-Frampton-West, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38802-50-2 Superintendent of Education. 3798 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 N° 579-52.Québec, le 11 décembre 1954.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 1er décembre 1954, de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Mathieu-de-Belœil, dans le comté de Ver-chères, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire du village de McMasterville, dans le même comté, savoir: Ce territoire comprend une partie des lots originaires 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 16, 18, 564 (chemin de fer Canadien National) et le lot 15 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Belœil, et toutes leurs subdivisions présentes et futures et les limites d'icelles, suivant ledit cadastre officiel, sont décrites comme suit, à savoir: partant du point d'intersection de.la ligne sud-ouest du lot I avec la ligne sud du lot 564 (emprise du chemin de fer Canadien National) de là passant par les lignes et limites en continuité les unes des autres: le prolongement de la ligne sud-ouest du lot I à travers ledit lot 564, ladite ligne traversant le boulevard Sir Wilfrid Laurier et continuant vers le nord-ouest jusqu'à un point partant à environ 550 pieds anglais du point de départ: une ligne traversant les lots 1, 2, 3, 4 et 7 passant par deux bornes établis sur le terrain, une passant à l'intersection de la ligne separative des lots 2 et 3 et l'autre à l'intersection de la ligne separative des lots 4 et 7 jusqu'au coin nord-ouest du lot originaire 9, une ligne brisée séparant les lots originaires 9,10 et 15 d'un côté des lots originaires 11 et 14 de l'autre côté, au coin nord dudit lot 15, une ligne traversant les lots originaires 16 et 18 dans une direction perpendiculaire aux lignes s'étendant au centre du chemin nommé \"Montée des Trente\", ladite Montée des Trente et son prolongement dans le boulevard Sir Wilfrid Laurier sur une longueur de 2450 pieds anglais, ledit prolongement continuant au côté sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National et enfin ledit côté sud de l'emprise du chemin de fer Canadien National en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38832-0 (Signé): O.J.DÉSAULNIERS.No.579-52.Quebec, December 11th, 1954.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council dated December 1st, 1954, to detach from the school municipality of Saint-Mathieu-de-Belœil, in the county of Verchères, the territory hereinafter described to annex it to the school municipality of the village of McMasterville, in the same county, to wit: This territory is comprised of part of the original lots 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 16, 18, 564 (Canadian National Railway), and lot 15 of the official cadastre of the parish of Saint-Mathieu-de-Belœil and all their present and future subdivisions and the limits thereof, according to the said official cadastre, are described as follows, to wit: starting from the point of intersection of the southwest line of lot I with the south line of lot 564 (Canadian National Railway right-of-way) ; thence, passing through the lines and limits successively; the prolongation of the southwest line of lot I across the said lot 564, the said line crossing the Sir Wilfrid Laurier Boulevard and continuing towards the northwest to a point starting at about 550 English feet from the starting point; a line crossing lots 1, 2, 3, 4, and 7 passing through two bounderies established on the land, one passing at the intersection of the dividing line of lots 2 and 3 and the other at the intersection of the dividing line of lots 4 and 7 to the northwest corner of the original lot 9, a broken line separating the original lots 9, 10 and 15 on one side of the original lots 11 and 14 on the other side, on the northern corner of the said lot 15, a line crossing the original lots 16 and 18 in a perpendicular direction to the lines extending to the centre of the road called \"Montée des Trente\", the said \"Montée des Trente\" and its prolongation in the Sir Wilfrid Laurier Boulevard upon a length of 2450 English feet, the said prolongation continuing on the southt side of the Canadian National Railway right-of-way and finally the said south side of the Canadian National Railway right-of-way going towards the west to the starting point.This Order in Council will take effect on July 1st, 1955.(Signed): O.J.DÉSAULNIERS, 38832 Superintendent of Education.N° 851-54.^ > Québec, le 11 décembre 1954.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 1er décembre 1954, de former en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"La municipalité scolaire de Clarke City, dans le comté de Saguenay\", le territoire ci-dessous décrit qui n'est pas encore organisé au point de vue scolaire.Cette future municipalité comprendra le bloc \"A\" du cadastre officiel du canton Leneuf et les blocs \"M\" et \"N\" du cadastre du canton Arnaud, tous dans le comté de Saguenay.Cet arrêté ministériel prendra effet 15 jours après sa passation.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38832-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.851-54.Quebec, December 11th, 1954.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated December 1st., 1954, has been pleased to form a separate school municipality, under the name of \"School Municipality of Clarke City, in the county of Saguenay\", with the territory hereinunder described, which territory is not as yet organized regarding schools.This proposed municipality will include block \"A\" of the official cadastre of township Leneuf and blocks \"M\" and \"N\" of the cadastre of township Arnaud, all in the county of Saguenay.This Order in Council will take effect 15 days after being enacted.O.J.DÉSAULNIERS, 38832 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 195A, Vol.86, No.61 3799 Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Joachim-de-Châteauguay.Avis est par la présente donné que les lots 97-163-27 à 97-163-156 et partie du lot 97-163-157; une partie du lot 97-163 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 novembre 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 38819-0 AVILA BÊDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Louis-de-Kamouraska, division d'enregistrement de Kamouraska.Avis est par la présente donné que les lots 392 à 417 sont annulés et remplacés par les lots 513 et 514 en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 8 novembre 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 38819-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Westbury (Ville de East Angus), division d'enregistrement de Compton.Avis est par la présente donné que le lot 12-12-1-A est annulé et les lots 12-12-2-A à 12-12-5-A et 12-12-6 à 12-12-34 du rang II sont corrigés en vertu des articles 2174A et 2174 du Code civil.Québec, le 29 novembre 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 38819-o AVILA BÉDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of St.Joachim-de-Châteauguay.Notice is hereby given that lots 97-163-27 to 97-163-156 and part of lot 97-163-157; part of lot 97-163 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 25th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 38819-o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of St.Louis-de-Kamouraska, registration division of Kamouraska.Notice is hereby given that lots 392 to 417 are cancelled and replaced by lots 513 and 514, in virtue of article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 8th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 38819-o Deputy Minister.- NOTICE Official cadastre of the township of Westbury (Town of East Angus), registration division of Compton.Notice is hereby given that lot 12-12-1-A is cancelled and lots 12-12-2-A to 12-12-5-A and 12-12-6 to 12-12-34 of range II are corrected in virtue of articles 2174A and 2174 of the civil Code.Quebec, November the 29th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD.38819-0 Deputy Minister.Examens du Barreau \u2014 Bars Examination BARREAU D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE \u2014 BAR OF ABITIBI-TÉMI8CAMINGUE -Candidat à l'examen pratique final Candidate to final practical examination Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tAdresse Address \t\t27\tVille-Marie.\t\t\t Malartic, 14 décembre 1954 \u2014 Malartic, December.14th, 1954.Le Secrétaire du Barreau d'Abitibi-Témisoamingue, * JEAN-PAUL LAMOUREUX, 3885 l-o Secretary of Abitibi-Témiscamingue Bar.BARREAU DU BAS SAINT-LAURENT \u2014 BAR OF THE LOWER ST.LAWRENCE Candidat pour l'admission à la pratique du droit Candidate for the admission to the practice of law Nom\tPrénom\t\tRésidence\tCollège _\t_\tAge\t_\t\u2014 Name\tSurname\t\tResidence\tCollege \t\t24\t\tUniversité de Montréal.\t\t\t\t Rimouski, le 10 décembre 1954 \u2014 Rimouski, December 10th, 1954.Le Secrétaire du Barreau du Bas Saint-Laurent, MAURICE TESSIER, 38851-0 Secretary of the Bar of the Lower St.Lawrence. 3S00 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1951, Tome 86, N° 51 BAKKKAI* DE MONTRÉAL \u2014BAR OV MONTREAL Candidat à i.'examen de décembre 1954 Candidate to the examination op December 1954 Examen rie reprise partielle (ancien régime rie trois ans) \u2022Supplementary Examinations (.Former three, years) Nom Name\t\tPrénom Surname\tAge\tRésidence Residence \t\tClaude.\t31\tMontréal.\t\t\t\t Montréal 38851-0.\tle 13 décembre 1954 \u2014 Montreal, December 13th, 1954.\t\t\tLe Secrétaire, ANDRÉ TESSIER.Secretary.\tOrdre de Cour\t\tRul\te of Court Canada, province de Québec, district de Québec, dans la Cour Supérieure, N° 74-510.Tri-Bec, demanderesse, vs Premier Cafeteria Inc., défenderesse; et Ascenseurs Alpin Cie Limitée, requérante.Avis dans la Gazette officielle de Québec.Avis est donné à tous les créanciers de la défenderesse ci-dessus mentionnée que par jugement de l'Honorable juge Marquis rendu le 20 novembre 1954, la défenderesse a été déclarée en dédéconfiture, et qu'appel leur est fait de produeri leurs réclamations dans les quinze jours de la date de la première insertion du présent avis, au Greffe de la Cour Supérieure, dans la cause ci-dessus mentionnée, pour être colloques suivant la loi dans la distribution qui sera faite des deniers provenant de la saisie et de la vente des biens de la défenderesse, et veuillez vous gouverner en conséquence.Québec, le 15 décembre 1954.Le Procureur de la requérante, 38854-51-2-o U.DÉSILETS.Canada, Province of Quebec, District of Quebec, in the Superior Court, No.74-516.Tri-Bcc, plaintiff; vs Premier Cafeteria Inc., defendant; and Ascenseurs Alpin Cie Limitée, petitioner.Notice in the Quebec Official Gazette.Notice is given to all creditors of the above-mentioned plaintiff that by a judgment of the Honourable judge Marquis, rendered on November 20th, 1954, the defendant has been declared insolvent and that an appeal is made to produce their claims within fifteen days from the date of the first insertion of the present notice to the office of the Superior Court, in the case hereinabove mentioned, to be collicated according to law in the distribution which shall be made of the moneys resulting from the seizure and of the sale of property of the defendant, and kindly be governed accordingly.U.DÉSILETS, Quebec, December 15th, 1954.38854-51-2 Attorney for the petitioner.Proclamations Proclamations Canada.Province de Québec.IL.S.) GASPARD FAUTEUX \\ Canada, Province of Quebec.[L.S.] GASPARD FAUTEUX ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses God of the United Kingdom, Canada and Her autres royaumes et territoires, Chef du Com- other Realms and Territories Queen, Head of monwealth, Défenseur de la foi, the Commonwealth, Defender of the Faith, A tous ceux qui ces présentes lettres verront To all to whom these presents shall come or ou qu'icellcs pourront concerner, whom the same may in anywise concern, Salut: Greeting: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une re-général, ) **¦ quête Nous a été C.E.Cantix.\\ présentée demandant ' qu'un certain territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Félicité soit détaché et annexé à la municipalité de Grosses-Roches, dans le comté municipal de Matane; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; PROCLAMATION C.E.Cantin, (\"VX/HEREAS a petition has Deputy Attorney ) W been submitted to Us, General.\\ requesting that a certain terri-' tory of the parish municipality of Saint-Félicité be detached and annexed to the municipality of Grosses-Roches, in the municipal county of Matane; Whereas the formalities prescribed by law to this effect have been complied with; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 .3801 Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande.A ces causes, du consentement et tie l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons par les présentes que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Cherbourg, comprenant, en référence au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Félicité, tout le lot et ses subdivisions présentes et à venir ainsi que tous les chemins, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant du point d'intersection de la ligne séparant les lots 214 et 215 avec le fleuve Saint-Laurent; de là, passant par les lignes et démarcations suivantes en continuité les unes des autres; ladite ligne séparant les lots 214 et 215; la ligne séparant les rangs I et II en allant vers le nord-ouest; la ligne séparant les lots 213 et 214 jusqu'à la rive du fleuve Saint-Laurent et enfin ladite rive du fleuve Saint-Laurent en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ; lequel territoire sera détaché de la municipalité de la paroisse de Sainte-Félicité, et sera annexé à la municipalité de Grosses-Roches, dans le comté municipal de Matane, telle annexion devant prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le tout conformément aux dispositions des articles 35 et suivants du Code municipal.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.) \u2022 ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi, A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: PROCLAMATION 1S Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une re-gênêral, ) quête Nous a été C.E.Cantin.\\ présentée d c m a n d a n t ' qu'un certain territoire de la municipalité du village de Mont-Saint-Pierre soit détaché et annexé à la municipalité Whereas it is expedient that this request be granted.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree elated November 24th, 1954, bearing number 1185, and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare that the following territory, to wit: A territory situated in the township of Cherbourg, comprising, with reference to the official cadastre of the parish of Saint Félicité, the entire lot and present and future subdivisions thereof, as well as all roads, rivers, streams or parts thereof enclosed within the following boundaries, to wit: Commencing at the point of intersection of the dividing line of lots 214 and 215 with the River St.Lawrence; thence, along the following lines and demarcations successively; the said line dividing lots 214 and 215; the line dividing ranges I and II running northwestwards; the line dividing lots 213 and 214 as far as the bank of the River St.Lawrence, finally the said bank of the River St.Lawrence, northeastwards, as far as the point of commencement; which territory shall be detached from the parish municipality of Saint Félicité, and shall be annexed to the municipality of Grosses-Roches, in the municipal county of Matane, which annexation to take effect as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, all of which pursuant to the provisions of articles 35 and the following of the Municipal Code.Of all Which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these our letters to be made patent and the great seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this fourth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-f ou rand in the third year of Our Reign.Bv Command.JEAN BRUCHÉSI, 3S818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender\"of the Faith, To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern.Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, ( Y\\7HEREAS a petition has Deputy Attorney ) * V been submitted to Us General.\\ requesting that a certain terri-' tory of the municipality of the village of Mont-Saint-Pierre dç detached and annexed to the municipality of Duchesnay, 3802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 de Duchesnay, dans le comté municipal de Gaspé-Ouest; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observés; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande.A ces causas du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185.et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de de Québec, Nous déclarons par les présentes que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans la seigneurie de Mont-Louis, comprenant, en référence au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Maximc-de-Mont-Louis, les lots de 1 à 13 inclusivement et une partie du lot 14 et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rivières, cours d'eau ou partie d'ieeux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la rive gauche de la Rivière à Claude avec l'extrémité nord-ouest de la ligne de division entre la seigneurie de Mont-Louis et le canton de Duchesnay; de là, passant successivement par les lignes et démarcation suivantes: ladite rive gauche de la Rivière à Claude jusqu'à la rive du golfe Saint-Laurent; ladite rive du golfe Saint-Laurent en allant vers l'est jusqu'à l'embouchure du Ruisseau du Petit-Cap; une ligne droite jusqu'au sommet .d'un angle de l'arrière-ligne des lots à l'ouest de la rivière Pierre vis-à-vis le lot 52A; ladite arrière-ligne des lots à l'ouest de la rivière Pierre jusqu'à la ligne de division entre la seigneurie de Mont-Louis et le canton de Duchesnay et enfin cette dernière ligne en la suivant vers le nord-ouest jusqu'au point de départ; lequel territoire sera détaché de la municipalité du village de Mont-Saint-Pierre et sera annexé à la municipalité de Duchesnay, dans le comté municipal de (Jaspé-Ouest, telle annexion devant prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date de li publication de la présente proclamation dans.la Gazette officielle de Québec, le tout conformément aux dispositions des articles 35 et suivants du Code municipal.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP.LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre.Le Sous-seciétaire de la province.38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada.Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L S.) in the municipal county of Gaspé-Wcst; Where as, all the formalities prescribed by law have observed; Whereas it is expedient that this request be granted; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated November 24th, 1954 bearing number, 1185 and pursuant to the provisions of the Municipal Code of out Province of Quebec, We hereby declare that the following territory, to wdt: A territory situate in the seigniory of Mont-Louis, comprising, with reference to the official cadastre of the parish of Saint-Maxime-de-Mont-Louis, lots 1 to 13 inclusively, and a part of lot 14 and their present and future subdivisions as well as the roads, rivers, water-courses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: starting from a point of intersection of the left bank of the Claude River with the northwest extremity of the dividing line between the seigniory of Mont-Louis and the township of Duchesnay; thence, passing successively by the following lines and demarcations: the said left bank of the Claude River, as far as the Saint-Lawrence Gulf; the said bank of the Saint-Lawrence Gulf towards the east to the mouth of the Petit-Cap brook; a straight line to the summit of an angle of the rear line of lots west of the Pierre River facing lot 52A; the said rear line of lots to the west of Pierre River, as far as the dividing line between the seigniory of Mont-Louis and the township of Duchesnay and finally this latter line by following same towards the northwest to the starting point; which territory shall be detached from the municipality of the village of Mont-Saint-Pierre and shall be annexed to the municiplity of Duchesnay, in the municipal county of Gaspé-West, such annexation to take effect as from January 1st following the date of publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, the whole in conformity with the provisions of sections 35 and following of the Municipal Code.Of all which Our loving subjects and all others whom these' presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.hi testimony whereof, We have caused these our letters to be made patent and the great seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX.P.C, LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this fourth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By command.JEAN BRUCHÉSI.38818 Under Secretary of the Province Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S:] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses God of the United Kingdom, Canada and Her QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1964, Vol.86, No.51 3803 autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procurcur / A TTENDU qu'une re-gênéral, ) quête Nous a été C.E.Cantin.\\ présentée demandant ( qu'un certain territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthc soit détaché et annexé à la municipalité du village de La Providence, dans le comté municipal de Saint-Hyacinthe; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons par les présentes que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans la seigneurie de Saint-Hyacinthe, faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, comprenant, en référence au cadastre officiel de ladite paroisse, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la rivière Yamaska avec la ligne sud-ouest du lot originaire 105; de là, passant par les lignes et démarcations suivantes, en continuité les unes des autres: ladite ligne sud-ouest du lot originaire 105 et la ligne sud-est du même lot jusqu'à la ligne separative des lots originaires 104 et 107; ladite ligne separative des lots originaires.104 et 107; la ligne nord-ouest du lot de subdivision, 104-111 (rue) ; la ligne sud-ouest des lots de subdivision 104-111 (rue), 104-112, 104-114.104-115, 104-116, 104-117 et 104-147 (rue); la ligne sud-est du lot de subdivision 104-147 (rue); la ligne nord-ouest et la ligne sud-est du lot originaire 104; la ligne nord-est du lot originaire 101 en allant vers le sud-est; la ligne sud-est des lots originaires 101.100.99, 98, 97 et 96; la ligne sud-ouest du lot 96 et enfin la rive de la rivière Yamaska en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ; lequel territoire sera détaché de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacin-the, et sera annexé à la municipalité du village de La Providence, dans le comté municipal de Saint-Hyacinthe, telle annexion devant prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le tout conformément aux dispositions des articles 35 et suivants du Code municipal.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos .présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin, /VW'HEREAS We have re\" Deputy Attorney ) * V ceived a petition re-General.\\ questing that a certain terri-' tory of the parish municipality of Notre-Dame-de-Saint-Hyacihthe be detached and annexed to the village municipality of La Providence, in the municipality county of Saint-Hyacinthe; Whereas the formalities prescribed by law, in this connection, have been complied with; Whereas it is expedient that this request be granted.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated November 24th, 1954, bearing number 1185, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare that the following territory, to wit: A territory situate in the Seigniory of Saint-Hyacinthe, actually forming part of the parish municipality of Notre-Dame-de-Saint-Hyacin-the, comprising, with reference to the official cadastre of said parish, all lots and present and future subdivisions thereof as well as roads, streets, lanes, streams or parts thereof enclosed within the following boundaries, to wit: commencing at the point of intersection of the Yamaska River with the southwest line of original lot 105; thence, along the following lines and demarcations, successively: the said southwest line of original lot 105 and the south-east line of the same lot as far as the dividing line of original lots 104 and 107; the said dividing line of original lots 104 and 107; the northwest line of subdivision lot, 104-111 (street); the southwest line of subdivisions lots 104-111 (street), 104-112, 104-114, 104-115.104-116, 104-117 and 104-147 (street); the southeast line of subdivision lot 104-147 (street) the northwest line and southeast line of original lot 104; the northeast line of original lot 101 running southeastwards; the southeast line of original lots 101, 100, 99, 98, 97 and 96; the southwest line of lot 96 and finally the bank of the Yamaska River running northeast-wards as far as the point of commencement; which territory shall be detached from the parish municipality of Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, and annexed to the village municipality of La Providence, in the municipality county of Saint-Hyacinthe, which annexation shall take effect as from January first following the date of publication of said Proclamation in the Quebec Official Gazette, all of which in accordance with the provisions of articles 35 and the following of the Municipal Code.Of all which Our loving subject and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have cause these Our letters to be made patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : \u2022 Witness: Our right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., 3S04 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1S décembre 19ÔJ,, Tome SC.N° 51 D.DiS., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce troisième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 3881 S-o JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.J ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada, et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-(jénéral, ) mande Nous a été C.E.Cantin.\\ faite à l'effet de détacher ' le territoire ci-après décrit des municipalités de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et de Notre-I)ame-dc-Ponlmain, dans le comté municipal de Labelle, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de Lac-du-Cerf\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec.Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire comprenant cette partie du canton de Dudley ainsi que les chemins, rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux et les îles dans la rivière du Lièvre dans les cantons de Wabassce et de Bouthillier, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection du prolongement de la ligne extérieure nord du canton de Dudley avec l'axe de la rivière du Lièvre; de là, successivement ledit prolongement et ladite ligne extérieure nord du canton de Dudley; la ligne extérieure est et la ligne extérieure sud du même canton jusqu'à la ligne separative des rangs VI et VII; dans ledit canton de Dudley, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud du lot 11.rang VI; partie de la ligne separative des rangs V et VI; la ligne nord du lot 22 du rang V prolongée jusqu'à l'axe du chenal de la rivière du Lièvre à l'est de l'île Longue; ledit axe dudit chenal; l'axe de la rivière du Lièvre en allant vers le nord-est et contournant par la droite les îles les plus rapprochées de* la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au point de départ; LL.I).D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec, (iiven at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this third day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.Bv Command, JEAN BRUCHÉSI, 3SS1S Under Secretary of the Province.( 'anada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.J ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of (iod of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: PROCLAMATION CE.Cantin, (TV/HEREAS a request has Deputy Attorney) »Y been submitted to Us General.\\ for the purpose of detaching \\ the territory hereinafter described of the municipalities of Saint-Aimé-du-Lac-dcs-Ues and of Notre-Dame-de-Pontmain, in the municipal county of Labelle.and to erect it into a separate municipality under the name of \"municipality de Lae-du-Cerf\", in the same municipal county; Whereas, all the provisions of the law have bee,n observed; Whereas it is expedient to comply with this request; Whereas, by virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force on January first from and after ¦the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in an Order bearing number 1185 dated November.24th, 1954 and pursuant to the provisions of the Municipal Code, of Our Province of Quebec.We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit : A territory comprising that part of Dudley township as well as the roads, rivers, lakes, watercourses or part thereof and the islands in the du Lièvre River in the Wabassec and Bouthillier townships, enclosed within the following limits, to wit: starting from the point of intersection of the prolongation of the exterior line north of the township of Dudley with the axis of the du Lièvre River; thence, successively the said prolongation and the said exterior line north of the township of Dudley; the east exterior line and the south exterior line of the same township to the dividing line of ranges VI and VII; in the said township of Dudley, part of the dividing line of ranges VI and Vll; the south line of lot 11, range VI, part of the dividing line of ranges V and VI; the north line of lot 22 of range V prolonged to the axis of the channel of the du Lièvre River to the east of Ile Longue; the said axis of the said channel; the axis of the du Lièvre River going towards the northeast and passing on the right the islands the nearest to the left bank and on the left bank, the islands the nearest to the right bank to the starting point; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 195A, Vol.86, No.51 3805 lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché des municipalités de Saint-Aimé-du-Lae-des-Iles, et de Notre-Dame-de-Pontmain, dans le comté municipal de Labelle, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de Lac-du-Cerf\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamât ion eut rera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, ('.P.LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce septième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de G A Sl'A HI ) FA l ÎTE l ' X Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-l'ni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: which territory shall, from and after the first \u2022lay of January following the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipalities of Saint-Aimé-du-Lac-dcs-Iles*and of Notre-Dame-de-Pontmain, in the municipal county of Labelle.and shall be erected into a separate municipality, under the name of \"municipality of Lac-du-Cerf\", in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on January first following the date of its publication in the Quebec Official Gazelle.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern t hemselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal Our Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trustv and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.(iiven at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, the seventh day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 3SSIS Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom.Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern.Greeting: PROCLAMATION VAssistant-procureur ( A TTENDU qu'une re-général, ) quête Nous a été C.E.Cantin.\\ présentée demandant \\ qu'un certain territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Félicité, dans le comté municipal de Matane.soit détaché et érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Sainte-Félicité\"; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons par les présentes que le territoire, suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Saint-Denis comprenant, en référence au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Félicité, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent avec la PROCLAMATION C.E.Cantin, ( T\\7HEREAS a request has Deputy Attorney ) W been submitted to Us General.\\ requesting that a certain terri-\\ tory of the municipality of the parish of Sainte-Félicité, in the municipal county of Matane, detached and erected into a separate municipality under the name of \"municipality of the village of Sainte-Félicité\"; Whereas all the formalities prescribed by-law have been observed; Whereas it is expedient that this request be granted; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated November 24th, 1954, bearing number 1185, and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec.We hereby declare that the following territory, to wit: A territory situate in the township ofASaint-Denis comprising, with reference of the official cadastre of the parish of Sainte-Félicité, all the lots of their present and future subdivisions as well as the roads, streets, lanes, water-courses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: starting from the point of intersection of the bank of the St.Lawrence River with 3806 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 ligne séparant le lot 53 des lots 54-1 et 54-6; de là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne séparant le lot 53 des lots 54-1 et 54-6; la ligne separative des rangs II et III en allant vers le sud-ouest; la ligne separative des lots 65 et 66 dans le rang II; la ligne separative des rangs I et II en allant vers le nord-est; la ligne séparant les lots 19-1 et 19-4 des lots 20-1, 20-3 et 20-9 et enfin la rive du fleuve Saint-Laurent en la suivant vers l'est jusqu'au point de départ; lequel territoire, ensemble avec la grève et toutes constructions quelconques qui sont présentement érigées ou qui seront érigées à l'avenir dans le fleuve Saint-Laurent en front d'icelui, sera détaché de la municipalité de la paroisse de Sainte-Félicité, dans le comté municipal de Matane, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Sainte-Félicité\", telle érection devant prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le tout conformément aux dispositions des articles 35 et suivants du Code municipal.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-o JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.IL.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut:\u2022 PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU QUE, sous général, ) l'autorité des dispo- C.E.Cantin.\\ sitions de l'article 2 de ' la loi relative aux titres de propriété dans la Gaspésie et le district électoral de Saguenay ( 12 Geo.VI, chapitre 37 et 14-15 Geo.VI, chapitre 39), le ministre des terres et forêts a fait dresser des plans et livres de renvoi revisés: 1.Pour une partie du canton de Cap-Chat, comprenant les lots 1 à 14 et leurs subdivisions respectives de la municipalité de Ste-Anne-des-Monts et les lots 15 à 32 et leurs subdivisions respectives de la municipalité de la paroisse de the line dividing lot 53 from lots 54-1 and 54-6; thence, passing successively through the following lines and demarcations: the said line dividing lot 53 from lots 54-1 and 54-6; the dividing line of ranges II and III going towards the southwest; the dividing line of lots 65 and 66 in range II; the dividing line of ranges I and II going toward the northeast; the line dividing Jots 19-1 and 19-4 from lots 20-1, 20-3 and 20-9 and finally the bank of the St.Lawrence by following it towards the east to the starting point; which territory, together with the beach and all buildings whatsoever which arc presently erected ot wdiich shall be erected in future in the St.Lawrence River in front of the latter, shall be detached from the municipality of the parish of Sainte-Félicité, in the municipal county of Matane, and shall be erected into a separate municipality under the name of \"municipality of the village of Sainte-Félicité\" such, erection to take effect from and after January 1st following the date of the publication of this present proclamation in the Quebec Official Gazette, the whole pursuant to the provisions of sections 35 and following of the Municipal Code.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trustv and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this fourth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \"V\\7TIEREAS under the au-Deputy Attorney) W thority of the provi-General.\\ sions of section 2 of the Act \\ respecting title-deeds in the Gaspesian area and the electoral district of Sa-guanay (12 Geo.VI, chapter 37 and 14-15 Geo.VI, chapter 39) the Minister of Lands and Forest has caused a revised plan and book or reference to be draw up: 1.For a part of the township of Cap-Chat, including lots 1 to 14 and their respective subdivisions of the municipality of Ste-Anne-des-Monts and lots 15 to 32 and their respective subdivisions of the municipality of the parish of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.80, No.51 3807 St-Norbert-du-Cap-Chat, division d'enregistrement de Ste-Anne-des-Monts; 2.Pour la municipalité de Havre-St-Pierre, division d'enregistrement de Saguenay; Attendu que, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de ladite loi, il a fait déposer: 1.Pour cette partie du canton de Cap-Chat, ci-haut décrite: a) les originaux du plan et du livre de renvoi revisés, aux archives du département des terres et forêts, le 22 octobre 1954: b) une copie de ces plan et livre de renvoi revisés, au bureau de la division d'enregistrement de Ste-Anne-des-Monts, à Ste-Anne-des-Monts, le 29 octobre 1954; c) une copie de ces plan et livre de renvoi révisés, au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation municipale de Ste-Anne-des-Monts et au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation municipale de la paroisse de St-Norbert-du-Cap-Chat, le 28 octobre 1954; 2.Pour la municipalité de Havre-St-Pierre: a) les originaux du plan et du livre de renvoi revisés, aux archives du département des terres et forêts, le 10 septembre 1954; b) une copie de ces plan et livre de renvoi révisés, au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay, à Tadoussac, le 25 septembre 1954; c) une copie de ces plan et livre de renvoi revisés, au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation municipale de Havre-St-Pierre, le 25 septembre 1954.Attendu Qu'il y a lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite loi.A ces causes, de l'avis et du consentement de Notre Cors?il Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1194, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons l'application aux localités désignées ci-dessus, des dispositions de la loi relative aux titres de propriété dans la Gaspésie et le district électoral de Saguenay (12 Geo.VI, chapitre 37*et 14-15 Geo.VI, chapitre 39).et la publication de la présente proclamation; a) fixant au 8 janvier 1955, la date de l'entrée en vigueur des plans et livres de renvoi revisés pour les diverses localités ci-haut décrites; b) indiquant qu'une copie de ces plans et livres de renvoi révisés a été déposée, pour les localités ci-haut décrites, aux bureaux des divisions d'enregistrement concernés et aux bureaux des secrétaires-trésoriers des corporations municipales concernées; c) informant le public que, pendant les huit mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle de Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plans et livres de renvoi revisés; d) portant notification que, à l'expiration de ce délai, et à moins d'opposition écrite d'un intéressé, l'honorable ministre des terres et forêts délivrera un certificat «le propriété à tout occupant d'un immeuble inscrit aux plans et livres de renvoi révisés des diverses localités ci-haut décrites;- e) ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le cadastre des diverses localités ci-haut mentionnées, pour lequel des plans et livres de renvoi revisés ont été déposés, soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172A du Code civil; St-Norbert-du-Cap-Chat, registration division of Ste-Anne-des-Monts; 2.For the municipality of Havre-St-Pierre, registration division of Saguenay; Whereas, pursuant to the provisions of sections 2 and 3 of the said Act, he has caused to be deposited: 1.For that part of the township of Cap-Chat, hereinabove described : a) the originals of the revised plan and book of reference, in the archives of the Department of Lands and Forests, on October, 22nd, 1954; b) copy of said revised plan and book of reference, in the office of the registration division of Ste-Anne-des-Monts, at Ste-Anne-des-Monts on October, 29th.1954; c) copy of said revised plan and book_ of reference, in the office of the Secretary^trSasurer of the municipal corporation of Ste-Anne-des-Monts and of the office of the Secretary-treasurer of the municipal coqwration of the parish of St-Norbert-du-Cap-Chat, on October 28th, 1954; 2.For the municipality of Havre-St-Pierre: a) the originals of the revised plan and book of reference, in the archives of the Department of Lands and Forests, on September 10th, 1954; b) a copy of said revised plan and book of reference., in the office of the registration division of Saguenay.at Tadoussac, on September 25th, 1954; c) a copy of sai I revised plan and book of reference, in the office of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of Havre-St-Pierre, on September 25th, 1954.Whereas it is expedient to issue the proclamation provised for in section 4 of the said Act.Therefore, with the advice and consent of the Executive Council expressed in a decree dated December 1st, 1954, bearing number 1194, We have decreed and ordained and, hereby decree and ordain that the provisions cf the Act respecting title-deeds in the Gaspesian area and the electoral district of Saguenay (12 Geo.VI, chapter 37 and 14-15 Geo.VI, chapter 39) be applied to the localities hereinabove designated, and publication of this Proclamation: a) fixing January 8th, 1955, as the date of the comi?:g into force of the revised plan and book of reference for the different localities hereinabove described ; b) indicating that copy of the said plans and books of reference has been deposited, for the localities hereinabove mentioned, in the offices of the registration divisions concerned, and in the offices of the secretary-treasurer of municipal corporations concerned ; c) informing the public that, during the eight months following the second and last publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, any interested party may consult, free of charge, the said revised plans and books of reference; d) giving notice that, at the expiration of said delay except in the case of written opposition by an interested party, the Honourable the Minister of Lands and Forests shall deliver a certificate of ownership to any occupant of an immoveable registered in the revised plans and books of reference of the different localities hereinabove described ; c) ordering that any real right affecting a lot comprised in the cadastre of the different localities mentioned hereinabove, for which revised plans and books of reference have been deposited, be renewed with in the same delay, in the manner, prescribed by articles 2172 and 2172A of the Civil Code; 3808 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql rÊBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, A70 51 /) informant aussi le public que, à défaut , 1954 bearing number 1185, and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory situate in the township of Brough-ton, comprising, with reference to the official cadastre of the said township, lots 46A, 47, 48, 48A and 49 of range I and their present and future subdivisions as well as the roads, streets, lanes, railroad right-of-way, water courses or part thereof, enclosed within the following limits, to wit: on the northeast, the northeasterly exterior line of the township; on the southwest, the dividing line of ranges I and II; on the southeast, the dividing line of lots 49 and 50 of range I; on the northwest, the dividing line of lots 46 and 46A; which territory shall, from and after the first day of January following the date of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the municipality of the parish of Saint-Jules, in the municipal county of Beauce, and shall be annexed to the municipality of the village of Tring-Junction, in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force On the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly. 3812 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre m.',.Tome 86, N° 51 En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honora-i ble GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., | D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trustv and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX.P.C., LL.D., I).O.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.(îiven at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this ninth day of December in the year of Our Lord, one thousand three hundred and fifty-four and in Uie third year of Oui- Reign.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHESI.Bv Command, JEAN BRUCHSÊI, Under Secretary of the Province.Canada.Province de Québec.IL.S.] GASPARD FAUTEUX 3SS1S Canada, Province of Quebec.[L.S.] GASPARD FAITKUX ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine «lu Royaume-Uni.du Canada et de ses God of the United Kingdom.Canada and Her autres royaumes et territoires.Chef «lu Com- other Realms and Territories Queen, Head of monwe.'dth.Défenseur «le la foi.the Commonwealth, Defender of the Faith.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou To all to whom these presents shall come or qu'icelles pourront concerner, whom the same may concern, Salut: Greeting: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-général, ) mande Nous a été C.E.Cantin.\\ faite à l'effet «le détacher ' le territoire ci-après décrit «le la municipalité du canton de Sutton, dans le comté municipal «le Brome, et de l'annexer à la municipalité «lu village d'Abercom, dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par lu loi à cet égard ont été observées; Attendu qu'il est opportun de se rendre à cette «lemande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 «lu Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication «lans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en «late du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province «le Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Sutton, comprenant, en référence au cadastre officiel pour le dit canton, les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, emprise de chemin de fer, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du coin sud-ouesi, du lot 1 étant en même temps le coin sud-ouest du susdit canton; de là, passant successivement par les lignes suivantes: la ligne extérieure ouest du canton de Sutton limitant à l'ouest les lots 1, 263, 204, 266, 267, 268, 269, 507 et 508; la ligne separative des rangs IV et V limitant au nord les lots 508, 506, 505, 501, 500, 499 et 498; partie de la ligne est du lot 498; la ligne nord du lot 497; partie de la ligne ouest, la ligne nord et partie de la ligne est du lot 495; la ligne nord des lots 492 et 486; la ligne est des lots 486, 302, 303, 181, 25 et 24; la ligne extérieure sud du canton de Sutton limitant au sud les lots 24 et 23; la ligne ouest des lots 23, 22, 21, 182 et 183; la PROCLAMATION C.E.Cantin, (YW'HEREAS a request has Deputy Attorney ) VV been presented to Us General.\\ for the purpose of detaching ' the territory hereinafter described of the municipality of the township of Sutton, in the municipal county of Brome, and to annex it to the municipality of the village of Abercorn in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed; Whereas it is expedient to grant the said request; Whereas in virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 1st 1954 bearing number 1200 and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory situate in the township of Sutton, comprising, with reference to the official cadastre for the said township, lots and their present and future subdivisions as well as the roads, streets, lanes, railroad right-of-way, rivers, watercourses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: starting from the southwest corner of lot 1 being at the same time in the southwest corner of the said township; thence, passing successively by the following lines: the exterior westerlv line of the township of Sutton limiting on the west lots 1,263, 264, 266, 267, 268, 269, 507 and 508; the dividing line of ranges IV and V limiting on the north lots 508, 506, 505, 501, 500, 499 and 498 f part of the easterly line of lot 498; the northerly line of lot 497; part of the westerly line, the northerly line and part of the easterly line of lot 495; the northerly line of lots 492 and 486; the easterly line of lots 486, 302, 303, 181, 25 and 24; the exterior southerly line of the township of Sutton limiting on QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.61 3813 ligne nord du lot 183; partie de la ligne ouest du lot 181 ; la ligne sud et partie de la ligne ouest du lot 300; la ligne sud du lot 297; partie de la ligne est et la ligne sud, du lot 292; la ligne sud du lot 291; la ligne est des lots 201, 200, 259, 4 et 7 et enfin la ligne extérieure sud du canton de Sutton limitant au sud des lots 7, G, 3 et 1 jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité du canton de Sutton, dans le comté municipal de Brome, et sera annexé à la municipalité du village d'Aber-corn, dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D.D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dixième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-o JEAN BRUCHESI.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procurcur ( A TTENDU qu'une de-général, ) mande Nous a été C.E.Cantin.j faite à l'effet de détacher ' le territoire ci-après décrit de la municipalité du canton de Lctcllier, dans le comté municipal de Saguenay, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de Moisie\", dans le même comté municipal: Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.the south lots 24 and 23; the westerly line of lots 23, 22, 21, 182 and 1S3; the northerly line of lot 183; part of the westerly line of lot 181; the southerly line and part of the westerly line of lot 300; the southerly line of lot 297; part of the easterly line and the southerly line of lot 292; the southerly line of lot 291; the easterly line of lots 261, 260, 259, 4 and 7 and finally southerly exterior line of the township of Sutton limiting on the south lots 7, 6, 3 and 1 to the starting point; which territory shall, from the first of January following the date of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipality of the township of Sutton, in the municipal county of Brome, and shall be annexed to the municipality of the village of Abercorn, in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony wheheof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C.LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this tenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.1L.S.] ' ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of .God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern.Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \\\\7TIEREAS We have been Deputy Attorney ) requested to the effect General.\\ that the territory hereinafter ' described be detached from the municipality of the township of Letellier, in the municipal county of Saguenay, and erected Into a separate municipality, under the name of \"municipality of Moisie\", in the same municipal county; Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette. 3814 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de l.ctellier, comprenant, en référence au cadastre officiel dudit canton, tous les lots ou partie de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les-chemins, rues ruelles, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du coin nord-est du lot G, rang I; de là, suivant la limite est de la réserve indienne en passant par la ligne est du lot G, rang I sur une distance de 63.21 chaînes; puis dans le lot 5, rang I, deux lignes ayant les directions astronomiques et distances suivantes: S.57°l TE.-32.93 chaînes et S.13W0.-27.-1-1 chaînes jusqu'à la rive «lu Golfe Saint-Laurent; puis laissant la limite est de la réserve indienne, le prolongement de la dernière ligne décrite à travers les lots de grève No.4 et No.5; la limite sud du lot «le grève N° 5 en allant vers l'est et son prolongement, se maintenant à la même distance de la rive du golfe, jusqu'au prolongement de l'axe de la rivière Moisie; ledit prolongement et le«lit axe de la rivière Moisie jusqu'au prolongement d'une ligne de direction est astronomique, originant au coin nord-est «lu lot 6, rang I, et enfin ce dernier prolongement et cette «litc ligne jusqu'au point «le départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec.détaché de la municipalité du canton de Letcllier, dans le comté municipal de Saguenay, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité «le Moisie\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis «le prendre connaissance et «le se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; \u2022 Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur en Notre province de Québec., Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed iu a decree dated November 24th, 1954, bearing number 11S5, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, That the following territory, to wit: A territory situated in the township of Letellier, comprising, with reference to the official cadastre of said township, all lots or parts of lots ami present and future subdivisions thereof, as well as roads, streets, lanes, rivers, streams and parts thereof enclosed within the following boundaries, to wit: commencing at the northeast corner of lot 6.range I; thence, following the east boundary of the Indian Reserve passing by the cast line of lot 6, range I over a distance of 63.21 chains; then in lot 5, range I, two lines with the following astronomical directions and distances S.57°ll'E.-32.93 chains ami S.13W0.-27.44 «\u2022lieins as far as the shore of the Gulf of St.Lawrence; then leaving the east boundary of the Indian Reserve, the extension of the last line described across beach lots No.4 and No.5; the south boundary of beach lot No.5 running eastwards and its extension, maintaining the same distance from the (Juif shore, as far as the extension of the centre point of the Moisie River, as far as the extension of an easterly astronomical direction line, originating at the northeast corner of lot 6.range I, and finally, the latter extension of said line as far as the peint of commencement: which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the municipality of the township of Letellier, in the municipal county of Saguenay, ami shall be erected into a separate municipality, under the name of \"Municipality of Moisie\", in the same municipal county.That this'Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.¦ Or all Which Our loving subjects ami all others whom these presents may concern are hereby requirc«l to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have rendered Our present letters patent and upon same have set the Great Seal of Our Province of Quebec: Witness: Our Right Trusty and Well beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C.LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this ninth day of December, in the year nineteen-hundred and fifty-four of Our Lor«l ami the third year of Our Reign.Bv command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern.Greeting : QUEBEC CEE ICI AL GAZETTE, Quebec, December 18th, l'JôJ,, Vol.86, No.51 3815 PROCLAMATION PROCLAMATION L'Assistant-procurcur ( A TTENDU qu'une de-yénéral, ) fx mande Nous a été C.E.Cantin.1 faite à l'effet de détacher \\ le territoire ci-après décrit des municipalités de Pahos et Saint-François-de-Pabos, dans le comté municipal dcGaspé-Est, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de Petit-Pabos\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans la seigneurie de Pabos, comprenant tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, emprise de chemin de fer, rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, si savoir: partant du point d'intersection de la ligne separative des Seigneuries de Pabos et de Grande-Rivière avec la rive du golfe Saint-Laurent; de là, passant par les lignes et démarcations suivantes, en continuité les unes des autres: dans la Seigneurie de Pabos, en référence au cadastre officiel de la municipalité de Pabos, ladite rive du golfe Saint-Laurent jusqu'à la ligne separative des lots le et 'id du rang Est-du-Petit-Pabos; cette dernière ligne; la rive nord-est de la baie du Petit-Pabos jusqu'à la ligne separative des lots 10c et lia du rang Est-du-Petit-Pabos; ladite ligne separative des lots 10c et lia du rang Est-du-Petit-Pabos; la ligne sud et la ligne sud-ouest du lot 13a\" du rang II; la ligne separative des rangs II et III et enfin, ladite ligne separative des seigneuries de Pabos et de Grande-Rivière jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, quant à sa partie située dans le rang I et le rang Est-du-Pctit-Pabos, détaché de la municipalité de Pabos, quant à sa partie située dans le rang II, détaché de la munipalité de Saint-François-de-Pabos, dans le comte municipal de Gaspé-Est, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de Petit-Pabos\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-nimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieu tenant-gouverneur de Notre province de Québec.C.E.Cantin, (\"V\\7'HEREAS a request has Deputy Attorney ) * * been submitted to Us General.\\ for the purpose of detaching v the territory hereinafter described from the municipalities of Pabos and Saint-François-de-Pabos, in the municipal county of Gaspé-East, and to erect it into a separate municipality under the name of \"municipality of Petit-Pabos\", in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas by virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force on January 1st following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 1st 1954 bearing number 1200 and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory situate in the seigniory of Pabos, comprising all lots and their present and future subdivisions, as well as roads, railroad right-of-way, rivers, lakes, water courses or part thereof, enclosed within the following limits, to wit: starting from the point of intersection in the dividing line of the seigniories of Pabos and of Grande-Rivière with the bank of the Gulf of the Saint-Lawrence; thence, passing sucessively by the following lines and demarcations; in the seigniory of Pabos, with reference to the official cadastre of the municipality of Pabos, the said bank of the Gulf of the St.Lawrence to the dividing line of lots 1c and Id of range East-of-Petit-Pabos; this latter line; the northeast bank of the Petit-Pabos Baie to the dividing line of lots 10c and 11a of range East-du-Petit-Pabos; the said dividing line .of lots 10c and 11a of range East-du-Petit-Pabos; the southern line and the southwesterly line of lot 13rf of range II; the dividing line of ranges II and III and finally, the said dividing line of the seigniories of Pabos and Grande-Rivière to the starting point; which territory shall, from and after the first of January following the date if the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette insofar as its part situate in range 1 and range _ East-du-Petit-Pabos, detached from the municipality of Pabos, insofar as its part situate on range II, detached from the municipality of Saint-François-de-Pabos, in the municipal county of Gaspé-East, and shall be erected into a separate municipality, under the name of \"municipality of Petit-Pabos\", in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on January first following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, Wc have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C.LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec. 3816 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 61 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce onzième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province.38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.IL.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur i A TTENDU qu'une général, ) demande Nous a été \u2022 C.E.Cantin.\\ faite à l'effet de détacher \\ le territoire ci-après décrit de la municipalité des cantons-unis de Sheen, Esher.Aberdeen et Malakoff, dans le comté municipal de Pontine, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de Ra-pides-des-Joachims\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis-de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire, situé dans le canton d'Aberdeen, comprenant, en référence au cadastre officiel dudit canton, tous les lots ou parties de lot et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, ruelles, rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la rive gauche ou rive nord de la rivière Outaouais avec la rive gauche ou rive est de la rivière Dumoine; de là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: ladite rive gauche ou rive est de la rivière Dumoine jusqu'à la ligne extérieure nord-ouest du canton d Aberdeen; cette dernière ligne en allant vers le nord-est; la ligne extérieure nord-est et la ligne extérieure sud-est du canton d'Aberdccn, cette dernière prolongée jusqu'à la ligne interprovinciale dans la rivière Outaouais; ladite ligne interprovinciale en allant vers l'ouest jusque vis-à-vis le côté est de l'embouchure de la rivière Dumoine et enfin une ligne droite jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this eleventh day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.Bv Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec, [L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, / VL7T1EREAS We have been Deputy Attorney ) *V requested to the effect General.j that the territory hereinafter 'described be detached from the municipality of the united townships of Sheen, Esher, Aberdeen and Malakoff, in the municipal county of Pontine, and that it be erected into a separate municipality, under the name of \"Municipality of Rapides-des-Joachims\", in the same municipal county; Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; Wheruas it is expedient that this request be granted; .Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette, Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 1st., 1954, bearing number 1200, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and decree, That the following territory, to wit: A territory, situated in the township of Aberdeen, comprising, with reference to the official cadastre of said township, all lots or parts thereof and present and future subdivisions thereof, as well as roads, streets, lanes, rivers, lakes, streams or parts thereof, included within the following boundaries to wit: commencing at the point of intersection of the left or north bank of the Outaouais River with the cast or left bank of the Dumoine River; thence, successively along the following lines and demarcations: the said left or east bank of the Dumoine River as far as the northwest outer line of the township of Aberdeen; the latter line running northeasterly; the northeast outer line and the southeast outer line of the township of Aberdeen, the latter extended as far as the interprovincial line in the Outaouais River; the said interprovincial line, westerly, as far as opposite the east side of the mouth of Dumoine River and finally a straight line as far as the point of commencement; which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this proclamation in the Quebec Official Gazette, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, * ol.86, No.51 3817 dc Quebec, détaché de la municipalité des cantons-unis de Sheen, Esher, Aberdeen et Malakoff, dans le comté municipal de Pontiac, et sera érigé en municipalité distincte sous le nom de \"municipalité de Rapides-des-Joachims\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette'officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau dc Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province dc Québec, ce onzième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et dc Notre Règne la troisième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire, de la Province.38818-0 JEAN BRUCHÉSI Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX,(par Iagrâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-gênéral, ) mande Nous a été C.E.Cantin.j faite d'ériger en municipa-' lité sous le nom dc \"municipalité dc Saint-Athanasc\", le territoire ci-après décrit situé dans le comté municipal dc Kamouraska; Attendu que ce territoire n'est pas actuellement organisé en municipalité; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle dc Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Chabot, comprenant, en référence au cadastre officiel dudit canton, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rivières, lacs, cours d'eau et partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point detached from the municipality of the united townships of Sheen, Esher, Aberdeen and Malakoff, in the municipal county of Pontiac, and shall be erected into a separate municipality under the name of \"Municipality of Rapides-des-Joachims\", in the same municipal county.That this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Oiir Province of Quebec.Given at our Government House in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this eleventh day of December in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty-four and the third year of Our Reign.By Command.JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province- Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faitli.\u2022 To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, (T\\7HEREAS We have been Deputy Attorney ) * ?requested to erect into General.\\ a municipality, under the name { of \"Municipality of Saint Atha-nase\", the territory hereinafter described and situated in the Municipal County of Kamouraska; Whereas this territory is not as yet organized as a municipality; Whereas the formalities prescribed by law to this effect have been complied with; Whereas it is expedient to grant this request; Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of publication of said Proclamation in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated November 24th, 1954.bearing number 1185, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, That the following territory, to wit: A territory situated in the Township of Chabot, comprising, with reference to the official cadastre of said Township, all lots and present and future subdivisions thereof, as well as roads, rivers, lakes, streams and parts thereof included within the following boundaries, to wit: commencing at the 3818 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 d'intersection de la ligne separative des rangs I et II du canton de Chabot, avec la ligne separative des cantons de Chabot et Pohénégamook; de là, passant successivement par la dite ligne separative des cantons de Chabot et Pohénégamook jusqu'à la ligne separative des rangs VIII et IX du canton de Chabot; puis dans le canton dc Chabot, la dite ligne separative des rangs VIII et IX jusqu'à la ligne separative des lots 27 et 28 du rang VIII; la dite ligne separative des lots 27 et 28 du rang VIII; la ligne separative des rangs VII et VIII, jusqu'à la ligne separative des lots 28 et 29 du rang VII; la ligne separative des lots 28 et 29 dc chacun des rangs VII, VI, V, IV III et II; et enfin la ligne separative des rangs I et II jusqu'au point de départ; lequel territoire, ne provenant d'aucune municipalité locale sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, érigé en municipalité, sous le nom de \"municipalité dc Saint-Athanasc\", dans le comté municipal de Kamouraska; Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la d.ate de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis dc prendre connaissance et de se conduire en conséquence En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, dc Notre province de Québec, ce neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre dc l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province dc GASPARD FAUTEUX Québec.|L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et dc ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur dc la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icclles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU q u 'une général, 1 demande Nous a C.E.Cantin, \\ été faite à l'effet de détail cher le territoire ci-après décrit dc la municipalité du canton dc Shcnley, dans le comté municipal de Beauce, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de la paroisse de Saiut-Honoré\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; point of intersection of the dividing line of ranges I and II of the township of Chabot with the dividing line of the townships of Chabot and Pohénégamook; thence, passing successively along the said dividing line of the townships of Chabot and Pohénégamook as far as the dividing line of ranges VIII and IX of the township of Chabot; then in the township of Chabot, the said dividing line of ranges VIII and IX as far as the dividing line of lots 27 and 28, range VIII; the said dividing line of lots 27 and 28 of range VIII; the dividing line of Ranges VII and VIII, as far as the dividing line of lots 28 and 29 of range VII; the dividing line of lots 28 and 29 of each of ranges VII, VI.V, IV, III and II; and finally the dividing line of ranges I and II as far as the point of commencement, which territory, not originating from any local municipality, shall be, as from the first day of January following the date of publictaion of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, erected into a municipality, under the name of \"Municipality of Saint Athanasc\", in the municipal county of Kamouraska; That this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which our loving subjects and all others whom these presents may concern arc hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Pat -nt and the Great Seal of Our Province of Que ec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Li utenant-Govemor of Our Province of Quebec.Given at Our Government II use, in Our city .of Quebec, in Our Province of Quebec, this ninth day of December in the year of Our Lord, one thousand three hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.v IL.S.1 ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwaclth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, (V17HEREAS Wc have been Deputy Attorney) * » requested to the effect General.\\ that the territory hereinafter ' described be detached from the municipality of the township of Shenley, in the municipal county of Beauce, and that it be erected into a separate municipality, under the name of \"Parish municipality of Saint-Honoré\".in the same municipal county: Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, \\ ol.86, No.61 3819 Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette efficiclle de Québec.A ces causes, du consentement et dc l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954.portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par Jes présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Shenley, se composant, en référence au cadastre officiel pour ledit canton, des lots ou partie de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que des chemins, cours d'eau ou partie d'iceux compris entre le périmètre extérieur et le périmètre intérieur ci-après décrit: 1° Périmètre extérieur: partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 381$ du rang XI; de là.successivement, la ligne nord des lots 381$ des rangs XI et X; la ligne separative des rangs IX et X en allant vers le nord; la ligne nord des lots 23B des rangs IX et VIII; la ligne séparât W ve des rangs VII et VIII en allant vers le sud; la ligne nord des lots 391$ des rangs VII et VI; là ligne separative des rangs V et VI en allant vers le sud; la ligne nord du lot 30A du rang V; la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud; la ligne nord du lot 141$ du rang IV; la ligne separative des rangs III et IV en allant vers le sud; la ligne separative des cantons de Shcnlev et de Dorset, sur la profondeur des rangs IV, V, VI, VII, VIII, IX du canton dc Shenley; le ligne separative des rangs IX et X en allant vers le nord; la ligne sud du lot 5A, rang X; la ligne separative des rangs X et XI en allant vers le nord; la ligne sud des lots 13A, 131$, 14A, 14B, 15A, 15B, 10, 17 A, 171$, 18B, du rang XI et enfin la ligne separative des-rangs XI et XII en allant vers le nord jusqu'au point dc départ; 2° Périmètre intérieur: partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 231$, rang IX; de là, successivement, la ligne nord des lots 231$, 24A, 24B, rang IX, 19A, 20A, 21A, 21 B, 22A.221$, 22C, 23, 21 du rang VIII et 19, 20Â, 201$.21 A, rang VII; la ligne separative des lots 21A et 211$.rang VII en allant vers le sud jusqu'à la demi-profondeur desdils lots; une ligne perpendiculaire auc lignes latérales traversant le lot 211$ du rang VII; la ligne separative des lots 211$ et 22A, rang VII en allant vers le sud; la ligne separative des lots 15 et 10, rang VII; la ligne sud des lots 10, 17A, 171$ et 18B, rang VII, 131$, 14A, 1 IB.15A.10A, 16B, 17A et ISA, rang VIII, 13D, 13F et 14C du rang IX; la ligne ouest des lots 14C et 141$, rang IX; la ligne nord du lot 14 B jusqu'à un point à la- demi-largeur du lot 14A; une ligue séparant la demie est et la demie ouest en largeur du lot MA, rang IX et enfin la ligne separative des lots 23A et 231$, rang IX jusqu'au point de départ ; lequel territoire sera, à compter du- premier janvier suivant la date de la publication dc la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité du canton de Shenley, dans le comté municipal de Beauce, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité de la paroisse de Saint-Honoré\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette efficielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres (pie les présentes peuvent concerner Whereas it is expedient that this request be granted : Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, the said Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Qu[ bee Official Gczttte.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council expressed, in a decree dated December 1st, 1954, bearing number 1200.and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, That the following territory, to wit: A territory situated in the township of Shenley, comprising, with reference to the official cadastre for said township, lots or parts of lots and present and future subdivisions, as well as roads, streams or parts thereof included between the outer pcrimenter and the inner perimeter hereinafter described; 1.Outer perimeter: commencing at the vertex of the northwest angle of lot 38B, range XI; thence, successively, the northern line of lots 38B, ranges XI and X; the dividing line of ranges IX and X.northwards; the northern line of lots 231$, ranges IX and Mil: the dividing line of ranges VII and VIII, southwards; the northern line of lots 391$, ranges VII and VI; the dividing line of ranges V and VI, southwards; the northern line of lot 30A.range V; the dividing line of ranges IV and V, southwards; the northern line of lot ll-B, range IV; the dividing line of ranges III and IV, southwards; the dividing line of the townships of Shcnlev and Dorset, along the depth of ranges IV, V, VI, VII.VIII, IX.township of Shenley; the dividing line of ranges IX and X northwards; the southern line of lot 5A, range X; the dividing line of ranges X and XI northwards; the southern line of lots 13A, 131$, 14A, 14B, 15A, 151$.10, 17A, 171$.181$, range XI and finally the dividing line of ranges XI and XII northwards as far as the point of commencement; 2.Inner perimeter: commencing at.the vertex of the northwest angle of lot 231$, range IX; thence, successive!v, the northern line of lots 231$, 2-IA, 241$.range IX.19A, 20A, 21A, 211$, 22A, 22B, 22C, 23, 24 range VIII and 19, 20A.201$.21 A, range VII: the dividing line of lots 21A and 211$, range VII southwards as.far as half the depth of said lots; a line perpendicular to the lateral lines crossing lot 211$, range VII; the dividing line of lots 211$ and 22A, range VII, southwards; the dividing line of lots 15 and 10, range MI; the southern line of lots 10, 17A, 171$, and 181$.range VII, 131$, 14A.141$, 15A, 16A, 101$, 17A and 18A range, VIII, 13D, 13F and 11C, range IX; the west line of lots 14C and 14B, range IX; the northern line of lot 14B as far as a point half the width of lot 14A; a line dividing the east half and west half of the depth of lot 14A, range IX, and finally the dividing line of lots 23A and 23B, range IX as far as the point of commencement; which territoty shall be, as from the first day of January following the publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazittc.detached from the township municipality of Shenley, in the municipality county of Beauce and shall be erected into a separate municipality, under the name of \"Parish municipality of Saint-Honoré\", in the same municipal county.That this Proclamation shall côme into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are 3820 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Ex foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-ainié l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité dc Québec, dc Notre province de Québec, ce dixième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-sccrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.j ELIZABETH DEUX, par la grâce dc Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icellcs pourront concerner.Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procurcur ( A TTENDU qu'une dc-génêral, ) mande Nous a été C.E.Cantin.\\ faite à l'effet de détacher ' le territoire ci-après décrit de la municipalité de Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay, dans le comté municipal dc Saguenay, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village dc Baie-Trinité\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé en partie dans le canton de DeMonts et en partie dans le canton de Roycr.comprenant, en référence au cadastre officiel desdits cantons, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dansj.es limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de l'axe de la rivière Poulin avec la rive du fleuve Saint-Laurent; de là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre officiel du canton de DeMonts, ledit axe de la rivière Poulin jusqu'à une ligne de direction sud astronomique originant au coin sud-ouest du lot 8, Baie-Trinité-Ouest; cette dernière ligne en la suivant dans la direction nord astronomique; la ligne nord-ouest dudit lot 8, Baie-Trinité-Ouest: une ligne hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trustv and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C.LL.D., D.D.S., L.D.S.Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this tenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By Command.JEAN BRUCHÉSI.38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \"VXTTIEREAS We have been Deputy Attorney ) requested to the effect General.\\ that the territory hereinafter ' described be detached from the Municipality of the Seven United Townships of Saguenay, in the municipal county of Saguenay, and erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Baie Trinité\", in the same municipal county; Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; Whereas it is expedient that this request be granted ; Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated November 24th, 1954, bearing number 1185, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, That the following territory, to wit: A territory situated partly in the township of DeMonts and partly in that of Royer, comprising, with reference to the official cadastre of said townships, all lots and present and future subdivisions thereof, as well as roads, rivers, streams or parts thereof included within the following boundaries, to wit: commencing at the point of intersection of the centre point of the Poulin River with the shore of the St.Lawrence River; thence, successively along the following lines and demarcations: with reference to the official cadastre of the township of DeMonts, the said centre point of the Poulin River as far as a south astronomical line of direction originating at the southeast corner of lot 8, Baie-Trinité-West; the latter line along a north astronomical direction; the northwest line QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 3821 droite joignant le coin nord-oucst dudit lot 8, Baie-Trinité-Ouest au poteau marqué \\5m sur la ligne separative des cantons de DeMonts et de Rover; puis dans le canton de Rover, une ligne dans la direction astonomique N.50°00'E.jusqu'à l'axe de la rivière Petit-Mai; ledit axe .de la rivière Petit-Mai jusqu'à la rive du fleuve Saint-Laurent et enfin ladite rive du fleuve Saint-Laurent en allant vers le sud-ouest jusqu'au point de départ; lequel territoire, ensemble avec les îles, îlets, grève et toutes les constructions qui sont ou seront érigées à l'avenir, situés dans le fleuve Saint-Laurent en front d'icelui, sera, à compter du premier janvier suivant la date dc la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché, quant à sa partie située dans le canton de DeMonts, de la municipalité dc Les Scpt-Cantons-Unis-du-Sagucnay, dans le comté municipal de Saguenay, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom dc \"municipalité du village dc Baie-Trinité\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres (pic les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Ex foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau dc Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité dc Québec, dc Notre province dc Québec, ce dixième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre dc l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 3881S-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada.Province de GASPARD FAUTEUX Québec.t [L.S.] ELIZABETH DEUX, par lagràce de Dieu, Reine du royaume-uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la fci.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Asùstnat-procureur ( A TTENDU qu'une de-général, ) ** mande Nous a été C.E.Cantin.\\ faite à l'effet de détacher ' le territoire ci-après décrit de la municipalité de Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay, dans le comté municipal de Saguenay, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom dc \"municipalité du village de Godbout\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées: of said lot 8, Baie-Trinité-West; a straight line connecting the northwest corner of said lot 8, Baie-Trinité-West to a post marked 15m on the dividing line of the townships of DeMonts and Royer; then in the township of Royer, a line in an astronomical direction, N.50°00'E., as far as the centre point of Petit-Mai River; the said centre point of Petit-Mai River as far as the shore of the St.Lawrence River and finally the said shore of the St.Lawrence River, southwes-erly, as far as the point of commencement; which territory, together with the islands, islets, beach and all buildings erected thereon or to be erected hereafter, situated in the River St.Lawrence or fronting thereon, shall, as from January first following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached, with respect to that part situated in the township of DeMonts, from the Municipality of the Seven United Townships of Saguenay, in the municipal county of Saguenay, and erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Baie-Trinité\", in the same municipal county.That this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this tenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command.JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting.PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \"W7HEREAS a request has Deputy Attorney ) »v j)Cen [submitted to Us General.\\ for the purpose of detaching ' the territory hereinafter described of the municipality of The Seven-United Townships of the Saguenay, in the municipal county of Saguenay, and to erect it intq a separate municipal county, under the name of \"municipality of the village of Godbout\", in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed: 3822 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, JV° 51 Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la.Gazette officielle de Québec.A ces Causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de DeMonts comprenant, en référence au cadastre officiel du canton de DeMonts, tous les lots et leurs subdivisions présentes et fuaires ainsi que les chemins, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point «l'intersection de l'axe de la rivière Godbout avec la rive du fleuve Saint-Laurent; dc là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: le dit axe de la rivière Godbout jusqu'au point d'intersection du prolongement dans la dite rivière de la ligne est du bloc \"A\" avec le prolongement de la ligne sud du dit bloc; le dit prolongement et la dite ligne est du bloc \"A\" jusqu'à une ligue de direction astronomique que S.53°00'0.originant au coin nord-ouest du lot 38 du village de Godbout; cette dernière ligne en la suivant dans la direction N.53°00'E.; la ligne nord du dit.lot 38 et son prolongement dans la direction est astronomique jusqu'à l'axe du ruisseau Blanc; le dit axe du ruisseau Blanc jusqu'à la rive du fleuve Saint-Laurent et enfin la dite rive du fleuve Saint-Laurent en la suivant dans des directions sensiblement ouest et sud jusqu'au point dc départ; lequel territoire, ensemble avec le lot de grève et en eau profonde 50 et toutes les constructions qui sont ou seront érigées à l'avenir, situés dans le fleuve Saint-Laurent vis-à*vis d'ieelui, sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité de Les Scpt-Cantons-Unis-du-Sagucnay, dans le comté municipal de Saguenay, et.sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"¦municipalité du village de Godbout\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date dc sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province dc Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dixième jour dc décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre dc l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-o JEAN BRUCHÉSI.Whereas it is expedient that this request be granted ; Whereas, by virtue of section 42, of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force from and after the first of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated December first, 1954, bearing number 1200, and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory situate in the township of DeMonts comprising, with reference to the official cadastre of the township of DeMonts, all lots and their present and future subdivisions as well as the roads, rivers, water-courses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: starting from the point of intersection of the axis of the Godbout River with the bank of the Saint-Lawrence River; thence, passing successively by the following lines and demarcations: the said axis of the Godbout River to the point of the intersection of the prolongation in the said river of the line east of block \"A\" with the prolongation of the line south of the said block, the said prolongation and the said east line of block \"A\" to a line in the astronomical direction S.53°00'0.originating in the northwest corner of lot 38 of the village of Dodbout; this latter line by following it in the direction N.53°00'E.; the northern line of the said lot 38 and its prolongation in an astronomically easterly direction to the axis of brook Blanc; the said axis of brook Blanc to the bank of the St.Lawrence River and finally the said bank of St.Lawrence River by following it in perceptibly westerly and southerly directions to the starting point; which territory, together with the beach lot and deep water 50 and all buildings which arc or shall be erected in future, situate in the St.Lawrence River facing same shall, as from the first of January, following the date of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipality of The Seven United Townships of the Saguenay.in the municipal county of Saguenay, and shall be erected into a seperate municipality, under the name of \"municipality of the village of Godbout\", in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force as from the first of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this tenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.HO, No.51 3823 Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icclles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procurcur ( A TTE N D U qu ' u ne (/encrai, ) *\\ demande Nous a été C.E.Cantin.J faite à l'effet de détacher {.le territoire ci-après décrit de la municipalité de Lac-des-Écorces, dans le comté municipal de Labelle, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom dc \"municipalité du village de Lac-des-Ecorces\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun dc se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date dc sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal dc Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Campbell, comprenant, en référence au cadastre officiel pour le susdit canton, tous les lots ou parties de lot et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne separative des lots 13 et 14 du rang sud-est avec la ligne séparant le rang sud-est des rangs F et G; dé là, successivement cl en continuité les unes des autres.ladite ligne séparant le rang sud-est des rangs F et G jusqu'à la ligne separative des lots 0 et 7, rang sud-est; cette dernière ligne prolongée jusqu'à l'axe de la rivière Kiamika; ledit axe en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 9B et 10 du rang I-nord-ouest; ledit prolongement et ladite ligne separative des lots 9B et 10 du rang I-nord-oucst; la ligne separative des rangs I-nord-ouest et II-nord-ouest en allant vers le nord-est; la ligne separative des lots 12 et 13, rang I-nord-ouest prolongée jusqu'à l'axe de la rivière Kiamika; ledit axe eu allant vers le sud-ouest, le sud-est et le nord-est jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 13 et 14, rang sud-est, et enfin ce dernier prolongement et cette dernière ligne jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date dc la publication dc la présente proclamation dans la Gaz'tie officielle dc Québec, détaché dc la municipalité de Lac-des-Ecorces, dans le comté municipal de Labelle, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Lac-des-Écorces\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Common wealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin, ( vv/HEREAS We have been Deputy Attorney) vv requested to the effect General.\\ that the territory hereinafter \\ described be detached from the municipality of Lac-des-Ecorces.in the municipal county of Labelle, and erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Lac-des-Écorces\", in the same municipal county; Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas pursuant to article 12 of the Municipal (.'ode, this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 1st, 1954.bearing number 1200, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact.That the following territory, to wit : A territory situate in the township of Campbell, comprising, with reference to the official cadastre for the abovemcntioned.township, all lots or parts of lots and present and future subdivisions thereof, as well as roads, streets, lanes, rivers, .streams or parts thereof, enclosed within the following bouandaries, to wit: commencing at the pojnt of intersection of the dividing line of lots 13 and 14, range south-east of ranges F and G; successively, said line dividing range south-cast of ranges F and G as far as the dividing line of lots 0 and 7, range south-east ; t he latter extended line as far as the centre point of the Kiamika River; the said centre point running northeastwards as far as the extension of the dividing line of lots 9B and 10, rang 1-north-wcsl ; said extension and said dividing line of lots 9B and 10.range I-north-west; the dividing line of ranges I-north-west and II-north-west running northeastwards; the dividing line of lots 12 and 13, range I-north-west extending as far as the centre point of the Kiamika River; the said centre point running southwestwards, southeast and northeast as far as the extension of the dividing line of lots 13 and 14, range south-east, and finally the latter extension and latter line as far as the point of commencement; ¦ which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the municipality of Lac-des-Ecorces, in the municipal county of Labelle, and erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Lac-des-Écorces\", in the same municipal County.That the proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazelle, 3824 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 De tout \"ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bicn-ainié l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur dc Notre province dc Québec?Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.IL.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pou riront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU q u ' u n e général, ) *» demande Nous a été C.E.Cantin, \\ faite à l'effet de détacher ( le territoire ci-après décrit dc la municipalité de Saint-André, dans le comté municipal de Lac Saint-Jean-Ouest, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom dc \"municipalité du village de Saint-André\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu qu'cu vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette cfficitlle de Québec.A ces causfs, du consentement et de l'avis dc Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province dc Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé partie dans le canton de Métabetchouan, partie dans le canton de Saint-Hilaire et partie dans le canton de Dequen, comprenant tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues ruelles, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant d'un point sur la ligne separative des cantons de Métabetchouan et dc Dequen marquant le sommet de l'angle sud-ouest du lot H-2 du cadastre officiel du canton de Métabetchouan; de là, dans le canton de Métabetchouan, en référence au cadastre officiel pour ledit canton, la ligne séparant le lot 29, rang VII des lots H-2, H-l, I et J du rang VI; la ligne séparant le lot 23 du lot 29.rang VI; la ligne separative des Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal Our Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this ninth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada.Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, ( W/HEREAS a request has Deputy Attorney ) VV oeen submitted to Us General.j to the effect of detaching the (territory hereinafter described of the municipality of Saint-André, in the municipal county of Lake Saint-John-West, and to erect it into a separate municipality, under the name of \"municipality of the village of Saint-André\", in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed; Whereas it is expedient that this request be grated ; Whereas by virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force on January first following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 1st, 1954, bearing number 1200.and pursuant to the provisions of article 35 of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents.That the following territory, to wit: A territory situate in the township of Métabetchouan, partly in the township of Saint-IIilai-re and partly in the township of Dequen, comprising all lots and their present and future subdivisions, as well as the roads, streets, lanes, rivers, water-courses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: starting at a point upon the dividing line of the townships of Métabetchouan and of Dequen marking the summit of the southwest angle of lot H-2 of the official cadastre of the township of Métabetchouan; thence, in the township of Métabetchouan, with reference to the official cadastre for the said township, the line dividing lot 29, range VII from lots H-2, H-l, I and J of range VI; the line dividing lot 23 from lot 29, range VI; the dividing QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1964, ^ ol.86, No.61 3825 lots 23 et 24 rang, VI prolongée à travers la rivière Métabetchouan et la ligne separative des lots 2111 22 du même rang; la ligne séparant le lot 16 des lots 21, 20, 19, 18, 1713 et 17A, rang VI; la ligne separative des rangs V et VI sur la largeur des lots 10, 15, 14, 12 et 11; la ligne separative des lots 10 et 11, rang VI et son piolongement dans le lac Labbé et continuant jusqu'à la ligne separative des cantons dc Métabetchouan et de Saint-Ililairc; la ligne separative des cantons de Métabetchouan it de Saint-Hilaire en allant vers l'est; puis dans le canton de Saint-Hilaire, eu référence au cadastre officiel pour ledit canton, la ligne séparant le lot 02 des lots 07, 001$, 00A, 051$ et 05A, rang I; la ligne separative des lots 04B et 65A, rang I; une ligne dans la rivière Métabetchouan joignant l'extrémité ouest de la dernière ligne nommée à l'extrémité est de la ligne séparant le lot 37B des lots 38A, 38B et 3SC, rang I, canton de Dequen, puis dans le canton de Dequen, ladite ligne séparant le lot 371$ de lots 38A, 381$ et 38C, rang I et la ligne séparant \\y.lot 35 des lots 38A, 39A, 40A et 41 du même rang; et enfin, la ligne separative des cantons de Métabetchouan et dc Dequen en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle dc Québec, détaché de la municipalité de Saint-André, dans le comté municipal de Lac Saint-Jean-Ouest, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-André\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous Mitres que les présentes peuvent concerner sont requis dc prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos \u2022 présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honora.-ble GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S.Lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce treizième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.line of lots 23 and 24, range VI prolongated through the Métabetchouan River and the dividing line of lots 21 and 22 of the same range; the line dividing lot 16 from lots 21, 20, 19, 18, 17B and 17A, range VI; the dividing line of ranges V and VI upon the width of lots 10, 15, 14, 12 and 11; the dividing line of lots 10 and 11, range VI and its prolongation into Lake Labbé and continuing to the dividing line of the townships of Métabetchouan and of Saint-Hilaire; the dividing line of the townships of Métabetchouan and of Saint-Hilaire going towards the east; then in the township of Saint-Hilaire, with reference to the official cadastre for the said township, le line dividing lot 02 from lots 07, GOB, G6A, G5B and G5A, range I; the dividing line of lots 64B and 65A, range I; a line in the Métabetchouan River joining the western extremity of the last mentioned line to the eastern extremity of the line dividing lot 37B from lots 38A, 38Band38C, range I, township of Dequen; then in the township of Dequen, the said line dividing lot 37B from lots 38A, 38B and 38C, range I and the line dividing lot 35 from lots 38A, 39A, 40A and 41 of the same range; and finally, the dividing line of the townships of Métabetchouan and of Dequen going towards the west to the starting point; which territory shall, from and after January first, following the date of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipality of Saint-André, in the municipal county of Lake St.John-West and shall be erected into a separate municipality, under the name of \"municipality of the village Saint-André\", in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on January first following, the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of au.of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice ami to govern themselves accordingly.In testimony whekeof, WeJiave caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this thirteenth day of December in the year of Our Lord, one' thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Province of GASPARD FAUTEUX Québec.Quebec.[L.SJ (L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, du Canada et dc ses God of the United Kingdom, Canada and Her autres royaumes et territoires, Chef du Com- other Realms and Territories Queen Head of monwealth, Défenseur de la foi.the Commonwealth, Defender of the Faith.A tous ceux qui ces présentes lettres verront To all to whom these presents shall come or ou qu'icelles pourront concerner, whom the same may in anywise concern, Salut: Greeting: 382(5 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre l'Jôh Tome 80, N° 61 PROCLAMATION L*Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-yé néral, ) mande Nous a clé C.E.Cantin.\\ faite à l'clfet de détacher ( le territoire ci-après décrit de la municipalité de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand, dans le comté municipal d'Ibcrville, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-Grégoire\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun dc se rendre à cette demande; Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette, officielle dc Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province dc Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire faisant actuellement partie «le la municipalité dc la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand, comprenant, en référence au cadastre officiel pour ladite paroisse, les lots ou partie de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 312; de là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: la ligne separative des lots 312 et 313 depuis le coin nord du lot 312 précité en la suivant vers le sud-est sur une longueur de deux mille huit cent quarante pieds anglais (2840'); une ligne droite traversant les lots 312, 311, 310, 309, 307, 304, 303, 282, la route N° 40A et les lots 279, 278, 277, 270 jusqu'à un point dc la ligne separative des lots 275 et 276 à une distance de cent trente-six pieds anglais (136') au sud-est du chemin public mesurée le long dc la ligne en dernier lieu nommée; ladite ligne separative des lots 275 et 276 en allant vers le nord-ouest et son prolongement jusqu'à l'axe du chemin du rang double; ledit axe dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 220; ledit prolongement, ladite ligne sud-ouest du lot 220 traversant le chemin entre Iberville et Marieville et continuant jusqu'à un point à une distance ce deux mille cent trente-six pieds anglais (2136') du côté nord-ouest dudit chemin entre Iberville et Marieville; une ligne droite traversant les lots 220, 204, 199, la route 40A et les lots 190, 193, 190, 189, 188, 184 et 183 jusqu'à un point de la ligne separative des lots 182 et 183 à une distance de deux mille cent quarante-deux pieds anglais (2142') mesurée le long de ladite ligne au nord-ouest du chemin entre Iberville et Marieville et enfin cette dite ligne sur la longueur de deux mille cent quarante-deux pieds anglais (2142') et son prolongement à travers ledit chemin ci tre Iberville et Marieville jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier jan-bier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand, dans le comté municipal d'Ibervillc, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-Grégoire\", dans le même comté muni- PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \"VV7HEREAS a request has Deputy Attorney ) VV hCen submitted to Us General.\\ for the purpose of detaching ' the territory hereinafter described of the municipality of the parish of Saint-Grégoirc-Ie-Grand, in the municipal county of Iberville, and to erect it into a separate municipality, under the name of \"municipality of the village of Saint-Grégoire\", in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed ; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas by virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force as from the first day.of January, following the date of the present publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent' of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 1200 dated December 1st, 1954 and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, That the following territory, to wit: A territory presently forming part of the municipality of the parish of Saint-Grégoire-le-Grand, comprising, with reference to the official cadastre for the said parish, lots or part of lots and their present and future subdivisions as well as roads, streets, lanes, water-courses or part of same enclosed within the following limits, to wdt: starting from the summit of the northern angle of lot 312; thence, passing successively by the following lines and demarcations: the dividing line of lots 312 and 313 from the northern corner of aforesaid lot 312 by following towards the southeast upon a Icnght of two thousand eight hundred and forty English feet (2S40'); a straight line crossing lots 312, 311, 310, 309, 307, 304, 303, 282, highway No.40A and lots 279, 278, 277, 270 to a point of the dividing line of lots 275 and 270 to.a distance of one hundred and thirty-six English feet (13C) southeast of the publics highway measured along the line in the place last mentioned; the dividing line of lots 275 and 270 going towards the northwest and its prolongation to the axis of the road of the double range; the said axis of the said double road to the prolongation of the southwest line of lot 220; the said prolongation, the said southwest line of lot 220 crossing the road between Iberville and Marieville and continuing to a point at a distance of two thousand one hundred and thirty-six English feet (2130') on the northwest side of the said road between Iberville and Marieville; a straight line crossing lots 220, 204, 199, highway 40A and lots 190, 193, 190, 189, 188, 184 and 183 to a point of the dividing line of lots 182 and 183 at a distance of two thousand one hundred and forty-two English feet (2142') measured along the said line northwest of the road between Iberville and Marieville and finally the said line upon the lenght of two thousand one hundred and forty-two English feet (2142') and its prolongation across the said between Iberville and Marieville to the starting point; which territory shall, from and after January first, following the date of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipality of the parish of Saint-Grégoire-le-Grand, in the municipal county of Iberville, and shall be erected into a separate municipality, under the name of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.86, No.51 3827 cipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date dc sa publication dans la Gazelle officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Ex foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau dc Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur dc Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, dc Notre province de Québec, ce dixième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre dc l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada.Province dc GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur dc la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur l A TTENDU qu'une dc-génêral, J mande Nous a été C.E.Cantin.\\ faite à l'effet de détacher ' le territoire ci-après décrit de la municipalité du canton de Chicoutimi, dans le comté municipal dc Chicoutimi, et de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-Jean-Eudes\", dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1200, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à sa voir: Un territoire situé dans le canton de Chicoutimi comprenant, en référence au cadastre officiel de la paroisse de Chicoutimi, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, emprise du chemin de fer, \"municipality of the village of Saint-Grégoire'' in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on the first of January following the date of the present publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters - to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Ou:1 city of Quebec, in Our Province of Quebec, this tenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.By Command.JEAN BRUCHÉSI, 38S18 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin, ( VV7HEREAS a petition has Deputy Attorney ) J)een submitted to Us General.\\ to the effect ôf detaching the \\ territory hereinafter described from the municipality of the township of Chicoutimi, in the municipal county of Chicoutimi, and to erect same into a separate municipality, under the name of \"municipality of the village of Saint-Jean-Eudes\", in the same municipal county; Whereas all the formalities prescribed by law have been observed; Whereas it is expedient that this request be granted ; Whereas by virtue of section 42 of the Municipal Code, the present proclamation shall enter into force on the first of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council expressed in a decree dated December 1st, 1954, bearing number 1200 and pursuant to the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory situate in the township of Chicoutimi, comprising, with reference to the official ca .'astre of the parish of Chicoutimi, all the lots and their present and future subdivisions as welj as the roads, streets, lanes, railway right-of-way 3828 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la rive de la rivière Saguenay avec la ligne separative des lots 7C et 8A du rang XlV-S.-O.-Chemin-Sydcnham; de là, successivement et en continuité les unes tics autres: ladite ligne separative des lots 7C et 8A, rang XlV-S.-O.-Chemin-Sydenhain; la ligne separative des rangs XLU-S.-O.-Chemin-Sydenham et XlV-S.O.-Chemin-Sydenham en allant vers le sud-est ; la ligne separative des rangs XII-S.O.-Chemin Sydenham et XIII-£.0.-Chemin-Syden-hain en allant vers le sud-ouest jusqu'à la limite de la cité d'Arvida; puis, suivant les limites dc la cité d'Arvida en passant par la ligne sud-ouest du lot 78.rang XHI-S.O.-Chemin-Sydenham et la ligne limitant au nord-ouest les lots 7B, 7A, 6B, 6A, 5, 4, rang XHI-S.O.-Chemin-Sydenham et le lot 9F, rang XlV-S.O.-Chemin-Sydcnham jusqu'à la rive de la rivière Saguenay; et enfin ladite rive de la rivière Saguenay en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazelle officielle de Québec, détaché de la municipalité du canton de Chicoutimi, dans le comté municipal de Chicoutimi, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-Jcan-Eudes\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CF., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce treizième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire dc la Province, 38818-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-général, ) mande Nous a été C.E.Cantin.j faite à l'elfet de détacher ( le territoire ci-après décrit de la municipalité du village de Saint-Michel, dans le comté municipal d'Yamaska, et de l'éri- watercourses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: starling from a point of intersection of the bank of the Saguenay River with the division line of lots 7C and 8A of range XIV-S.-W.-Sydenham-Road; thence, succcss-vely: the said divi ling line of lots 7C and 8A, range XIV-S.VY.-Sydenham-Road; the dividing line of ranges XIII-S.YV.-Sydenham-Road and XIV-S.W.-Sydcnham-Road going towards the southeast; the divi ling line of ranges XII-S.W.-Sydenham-Road and XIII-S.W.-Sy lerdiam-Road going towards the southwest to the limits of the city of Arvida; then, following the limits of the city of Arvida in passing by the southwesterly line of lot 7B, range XIII-S.W.-Sydenhani-Rond and the line limiting on the northwest lots 7B.7A, 6B, 6A, 5, 4, range XIII-S.W.-Sydenham-Road ami lot 9F, range XIV-S.W.-Sydenham-Road.to the bank of the Saguenay River; and finally the said bank of the Saguenay River going towards the southeast to the starting point; which territory shall, from \"and after the first of January following the date of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, be detached from the municipality of the township of Chicoutimi.in the municipal county of Chicoutimi, and shall be erected into a separate municipality under the name of \"municipality of the village of Saint-Jean-Eudes\", in the same municipal county.That the present proclamation shall enter into force on the first of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whekeof, We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this thirteenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four and in the third year of Our Reign.By Command, / JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting:, PROCLAMATION C.E.Cantin.( yv/HEREAS We have been Deputy Attorney ) »v requested to the effect General.S that the territory hereinafter \\ described be detached from the village municipality of Saint-Michel, in the municipal county of Yamaska, and that it be QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, Vol.80, No.51 3829 ger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Yamaska-Est\".dans le même comté municipal; Attendit que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 24 novembre 1954, portant le numéro 1185.et conformément aux dispositions du Code municipal dc Notre province de Québec.Nous déclarons et décrétons, par les présentes, Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans la seigneurie d'Yamas-ka, comprenant, en référence au cadastre officiel du village incorporé dc Saint-Michel, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, ruelles, emprise de chemin *de fer.île aux Érables et une partie de la rivière Yamaska.le tout renfermé dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne nord-ouest du lot 134 avec la rive dc la rivière Yamaska; dc là, successivement et en continuité les unes des autres, les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne nord-ouest du lot 134; une ligne droite limitant à l'est les lots 134, 116.115.81, 78 et 69; la ligne sud-est du lot 69 prolongée jusqu'à l'axe de la rivière Yamaska; ledit axe dc la rivière Yamaska en passant à l'ouest de l'île aux .Érables jusqu'à l'extrémité nord de ladite île; une ligne allant vers l'est jusqu'à l'axe du chenal de la rivière Yamaska à l'est de l'île aux Érables; ledit axe dudit chenal jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 134 et enfin ce dernier prolongement jusqu'au point dc départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité du village de Saint-Michel, dans le comté municipal d'Yamas-ka.et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Yamaska-Est\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce quE dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province dè Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce treizième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 3881S-0 JEAN BRUCHÉSI erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Yamaska-East\".in the same municipal county; Whereas the formalities prescribed by law in this connection have been complied with; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas pursuant to article 42 of the Municipal Code, this proclamation shall into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated November 24th.1954.bearing number 1185, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact.That the following territory, to wit: A territory situated in the Seigniory of Yamaska, comprising, with reference to the official cadastre of the incorporated village of Saint-Michel, all lots and present and future subdivisions thereof, as well as roads, streets) lanes, railroad right-of-way, He aux Erables, and a part of the Yamaska River, all of which is included within the following boundaries, to wit: commencing at a point of intersection of the northwest line of lot 134 with the bank of the Yamaska River; thence, successively, along the following lines and demarcations: the said northwest line of lot 134; a straight boundarv line east of lots 134, 116, 115, 81, 78 and 69; the southeast line of lot 69 extended to the centre point of the Yamaska River, the said contrepoint of Yamaska River passing west of Ile aux Érables as far as the northern end of said Island; a line running eastwards as far as the centre point of the Yamaska River channel cast of He aux Érables; the said centre point of said channel as far as the extension of the northwest boundary line of lot 134 and finally the latter extension as far as the point of commencement ; which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the village municipality of Saint-Michel, in the municipal County of Yamaska, and shall be erected into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Yamaska-East\", in the same municipal county.That this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this thirteenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-four, and in the third year of Our Reign.Bv Command, JEAN BRUCHÉSI, 38818 Under Secretary of the Province. 3S30 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 décembre 1954, Tome 86, N° 51 Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icclles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TI'ENDU (pie, con-général, ) ** formément aux dis- C.E, Cantin.j positions de la Loi du cadastre (Statuts refondus 1941, chapitre 320, article 2), l'honorable ministre des terres et forêts a fait préparer, sous sa direction, des plans et livres de renvoi pour chacune des localités désignés ci-dessous et comprises dans l'une des divisions d'enregistrement suivantes: 1.Division d'enregistrement de Lac-St-Jean Ouest d'une partie du canton de McKenzie, comprenant les rangs, I, II, III, IV, ainsi que le Bloc F.2.Division d'enregistrement deTémiscaminguc d'une partie dc la cité de Noranda, comprenant les lots 2070 et 2082.Attendu que ces plans et livres de renvoi font maintenant partie des archives du département des terres et forêts, et qu'une copie exacte en a été déposée au bureau de la division d'enregistrement concernée; Attendu Qu'en vertu des dispositions de l'article 2109 du Code civil, il y a lieu d'annoncer, par une proclamation du Lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt dc ces plans et livres de renvoi officiels, et de fixer en même temps la date où les dispositions de l'article 2108 du Code civil deviendront en vigueur pour ces localités désignées ci-dessus; A ces causes, de l'avis et du consentement dc Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 1er décembre 1954, portant le numéro 1193, Nous donnons avis du dépôt de ces plans et livres de renvoi officiels pour chacune des localités ci-dessus désignées, et Nous fixons à la date de la publication dc la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le jour auquel les dispositions de l'article 2108 du Code civil deviendront en vigueur relativement à chacune de ces localités; Nous invitons toute personne intéressée, à peine dc perdre la priorité conférée par le Code civil, à renouveler, dans les deux ans qui suivent la date fixée ci-dessus, l'enregistrement de tous droits réels sur un lot de terre compris dans chacune de ces localités, et dans leur division d'enregistrement respective.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.J ELIZABETH THE SECOND by the Grace of God of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyand the Sea, Queen, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, / yv/HEREAS in accordance Deputy Attorney ) *v with the provisions of General.\\ the cadastre Act (Revised Sta-\\ tutes 1941, chapter 320, section 2), the Honourable the Minister of lands and forests has caused to be prepared, under his superintendence, plans and books of reference for each of the locliics designated hereinunder and\" included in one of the following registration divisions: 1.Registration division of Lake St.John-West part of the township of McKenzie, comprising ranges I, II, III, IV, including Block F.2.Registration division of Témiscamingue part of the city of Noranda, comprising lots 2076 to 2082.Whereas the said plans and books of reference now form part of the Archives of the Department of lands and forests, and that a true copy has been deposited in the office of the registration division concerned; Whereas pursuant to the provisions of article 2109 of the Civil Code, it is expedient to announce by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of said official plans and books of reference, and to fix at the same time, the date on which the provisions of article 2109 shall come into force for the localities hereinabove designated ; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 1st, 195-1, bearing number 1193, We give notice of the deposit of said official plans and books of reference for each of the localities hereinabove designated, and We fix the date of publication of this proclamation in the Quebec Official Gazette as the day on which the provisions of article 2108 of the Civil (\"ode shall come into force respecting each one of the said localities; We invite all interested parties, under pain of losing the priority conferred by the Civil Code, to renew within two years following the date fixed hereinabove, the registration of any real rights to a lot of land comprised in each.of the said localities, and in each respective registration division.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimoney whereof, We have rendered Our present letters patent and upon same have set the (ïreat Seal of Our Province of Quebec.Witness: Our Right Trusty and Well beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 18th, 1954, V ol.86, No.51 3831 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de* Québec, de Notre province de Québec, ce quatorzième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-quatre de l'ère chrétienne et de Notre Règne la troisième année.Par ordre, Le Sous-secrétairc de la Province, 38819-0 JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'.icclles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU que l'ho-gênêral, ) ** norahle ministre des C.E.Cantin.\\ terres et forêts de Notre \\ province de Québec a fait préparer, sous sa direction, conformément au sous-paragraphe \"
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.