Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 janvier 1955, samedi 8 (no 1)
[" 1 Vol.87, No.1 y 4 t>?Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 8 janvier 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce'dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, January 8th, 1955 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.\"7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter, Authorized by the Canada Posl i 2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S janvier 1955, Tome 87, N° 1 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus.l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction:-50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933\u2014 1-52 Actions en séparation de biens Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 365288.Dame Rennée Mestre, de la cité de Montréal, épouse commune en biens d'Ernest Ramaglia, marchand du même endroit, a intentée une action en séparation de biens contre sondit époux.Le Procureur de la demanderesse, 38938 J.R.BOGANTE.Canada, Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 363,566.Dame Georgette Mcrtcns, épouse commune en biens de Sam Herscovitch, domiciliée et résidant au N° 1190 Bishop dans les cité et district de Montréal, demanderesse, vs Sam Herscovitch, marchand, domicilié et résidant au N° 4820 Ridgcvale avenue, dans les cité et district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été institué en cette cause le 8ième jour de Novembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, A.J.ROSENSTEIN.1117 rue, Ste-Catherinc ouest, Montréal.Le Député-Protonairc, C.S.M., 38943-0 RAOUL CREVIER.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governcment House.Quebec, June 27th, 1940.38983 \u2014 1-52 Actions for separation as to property Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.365288.Dame Rennée Mestre, of the city of Montreal, wife common as to property of Ernest Ramaglia, merchant of the same place, instituted an action in separation as to property from her said husband.J.R.BOGANTE, 38938-0 Attorney for the plaintiff.Canada, Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.363,566.Dame Georgette Mertens, wife common as to property of Sam Herscovitch, the former domiciled and residing at 1190 Bishop Street, in the city and district of Montreal, plaintiff, vs Sam Herscovitch, merchant, domiciled and residing at 4820 Ridgevale, avenue in the city and district of Montreal, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case on the 8th day of November, 1954.A.J.ROSENSTEIN, Attorney for the plaintiff.1117 Ste-Catherine west, Montreal.RAOUL CREVIER, 38943-o Dcputy-Prothonotary, S.C.M. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 3 Action en séparation de corps et de biens Canada, province de Québec, district d'Abi-tibi, Cour Supérieure, N° V-2650, François Aldcbcrt Gratton, ouvrier domicilié et demeurant au numéro 1147, 3e avenue, Val d'Or, district d'Abitibi, demandeur: vs, Dame Marie Jeanne Annette Guindon, épouse en communauté légale de biens du demandeur, avec qui elle a demeuré à Val d'Or, et maintenant demeurant à 1305, rue Papineau, ville de Montréal, district de Montréal, le demandeur autorisant ladite épouse a ester en justice aux fins des présentes, défenderesse.Une action en séparation de corps et de biens a été institutée en cette cause, le 3 juillet 1954.Val d'Or, ce 20 décembre 1954.Les Avocats, CLICHE et CLICHE.812-3c avenue, Val d'Or, Québec.38944-0 Action for Separation as to Bed and Board and Property Canada, Province of Quebec, district of Abi-tibi, Superior Court, No.V-2650, François Aldc-bert Gratton, carpenter, domiciled and residing at 1147, 3rd avenue, town of Val d'Or, district of Abitibi, plaintiff, vs Marie Jcaime Annette Guindon, wife who is in community as to property with the said François Aldebert Gratton, formerly residing at Val d'Or, and now domiciled and residing at 1305, Papineau Street, city of Montreal, same district, and the said François Aldebert Gratton who authorizes said Marie Jeanne Annette Guindon to appear in judicial proceedings, defendant.An action in separation from bed and board has been duly taken in this cause, July 3rd, 1954.Val d'Or, December 20th, 1954.CLICHE and CLICHE, Advocates.812, 3rd Avenue, Val d'Or, Quebec.38944-o Avis divers AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Hope Baptist Church\", de Hopetown, Québec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec pour obtenir sa constitution en corporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des \"Statuts refondus de la province de Québec, 1941, et amendements.Montréal, 4 décembre 1954.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231 ouest, rue St-Jacques, Montréal, Que.38778-50-5 The Royal Trust Company Avis est, par les présentes, donné que, par un vote de la majorité des actionnaires à une assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin et tenue le 16e jour de décembre 1954, le capital-actions de la compagnie The Royal Trust Company a été augmenté de deux millions de dollars (82,000,000) à deux millions cinq cent mille dollars ($2,500,000) par la création de cinq mille (5,000) actions additionnelles d'une valeur au pair de cent dollars (8100) chacune.Montréal, 16 décembre 1954.The Royal Trust Company Le Secrétaire, 38882-52-3 W.E.BICKLEY.Loi du régime des eaux courantes, Statuts refondus, 1941, chapitre 98.Formule 1 1.\u2014 (Article 8) Avis de la demande des plans et devis Avis est donné au public, conformément à l'article 8 de la Loi du régime des eaux courantes, que la Coopérative d'Électricité de Bonaventure, société coopérative formée sous l'empire de la Loi pour favoriser 1'Electrification rurale, 9 Miscellaneous Notices PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the \"Hope Baptist Church\", of Hopetown, Quebec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and amendments.Montreal, December 4th, 1954.CERINI & JAMIESON, \u2022 Solicitors for petitioner.231 St.James Street West, Montreal, Que.38778-50-5-o The Royal Trust Company Notice is hereby given that by a vote of the majority of the shareholders at a special general meeting duly called for the purpose and held on the 16th day of December, 1954, the capital stock of The Royal Trust Company was increased from two million dollars (82,000,000) to two million five hundred thousand dollars ($2,500,000) by the creation of five thousand (5,000) additional shares of the par value of one hundred dollars (8100) each.Montreal, 16th December, 1954.The Royal Trust Company W.E.BICKLEY, 38882-52-3-0 Secretary.Water-Course Act, Revised Statutes, 1941, chapter 98.Form 1 l.-t- (Section 8) Application and Notice of Deposit of Plan and Specifications.Public notice is hereby given in accordance with section 8 of the Water-Course Act, that the Bonaventure Electricity Cooperative, cooperative formed under the act to promote Rural 4 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 Georges VI chapitre 48, 1945, ayant son siège social à Bonaventure, dans le comte de Bona-venturc, se propose de demander l'autorisation de faire faire la construction d'un exhaussement au barrage sur le cours d'eau, dénommé Rivière Hall, qui traverse les lots suivants: 1.\u2014 Lot N° 8 du rang X ouest de Paspébiac* 2.\u2014 Lots Nos 4-5-0-7-8 du rang XI ouest de Paspébiac.3.\u2014Lots Nos 1-2-3-1 du rang XII ouest de Paspébiac.Avis est tie plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant l'emplacement choisi pour la construction de ces ouvrages et les terrains qui seront alfectés par le refoulement des eaux, a été transmise au ministre des ressources hydrauliques, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la 1ère division d'enregistrement de Bonaventure à New Carlisle.La demande contenue dans la requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.La Coopérative d'Électricité de Bonaventure, Requérante.Par le Président, OSCAR BUJOLD.Le Secrétaire-gérant, 38883-52-4-0 SÉBASTIEN FORTIN.(P.G.7760-45) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 17 décembre 1954, les nouveaux règlements de \"Naval Officers Club (Montreal) Inc.\", tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 27 novembre 1952, et le règlement numéro V révisé, tel qu'adopté à l'assemblée générale tenue le 17 novembre 1954, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix-septième jour de décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38939 JEAN BRUCHÊSI.Electrification, 9 Georges VI, chapter 48, 1945, having its head office in Bonaventure in' the county of Bonaventure, intends to apply for authorization to have constructed a raise on the dam on the water course, which passes across the following lots: 1.\u2014 Lot 8 rang X west of Paspébiac.2.\u2014 Lots 4-5-G-7-8 range XI west of Paspébiac.3.\u2014Lots 1-2-3-4 range XII west of Paspébiac.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications of such work, showing the site chosen for the construction thereof and the lands which will be affected by the backing up of the water, has been forwarded to the Minister of Hydraulic Resources, and that a duplicate of such plan and specifications has been deposited at the registry office of the first registration division of Bonayenture at New Carlisle.The application contained in the petition will be taken into consideration on or after the day following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.The Bonaventure Electricity Cooperative, \u2022 Petitioner.By: OSCAR BUJOLD, President.By: SÉBASTIEN FORTIN, 3S8S3-52-4-0 Manager.(A.G.7760-45) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the new By-laws of \"Naval Officers Club (Montreal) Inc.\", as adopted at the meeting held on November 27th, 1952, and the revised By-law number V, as adopted at the general meeting held on November 17th, 1954, were approved on December 17th, 1954, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this seventeenth day of December, 1954.JEAN BRUCHÊSI, 38939-o Under-Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Desjardins de St-Thomas Apôtre\", en date du 10 décembre 1954, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-neuf décembre 1954.N Le Sous-secrétaire de la Provindc, 38942-0 JEAN BRUCHÊSI.(P.G.10455-54) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé le 29 novembre 1954 le règlement N^ 1 de \"Canadian National Recreation Association Inc.(Montreal)\", conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire tie la Province, le 30c jour tie novembre 1954.Le Sous-secrétaire tie la Province, 38945 JEAN BRUCHÊSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the coopcratice syndicate \"La Caisse Populaire Desjardins de St-Thomas Apôtre\", under tlatc, December 16, 1954, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-ninth day of December, 1954.JEAN BRUCHÊSI, 38942 Under Secretary of the Province.(A.G.10455-54) Notice is hereby given that, upon the recom-dation of the Deputy Attorney General, Bylaw No.1 of \"Canadian National Recreation Association Inc.(Montreal)\" was approved on November 29th, 1954, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th tlay of November, 1954.JEAN BRUCHÊSI, 38945-0 Under Secretary of the Province./ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 5 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Marie Reine de la Paix\", en date du 28 novembre 1954, dont le siège social est situé à Rox-boro, dans le comté de Jacques-Cartier, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le seize décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38946-0 JEAN BRUCHÊSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Forestier de Fourniôre\", en date du 6 décembre 1954, dont le siège social est situé à Malartic, dans le comté d'Abitibi-Est\", et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le trente décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38951-o JEAN BRUCHÊSI.(P.G.4318-51) Amsel & Amsel Inc.Règlement N° % \"Sur proposition dûment faite et secondée, la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité: Qu'il soit résolu: Que le règlement N° 24 soit et il est présentement décrété en augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de trois à quatre directeurs.\" Certifié vraie copie.Le Président, L.AMSEL.Le Secrétaire-trésorier, 38959 MOE AMSEL.(P.G.3291-52) Montreal Cutting Company Limited Règlement N° H (Concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois (3) à cinq (5).\"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau composé de cinq directeurs lesquels seront élus pour un an par les actionnaires à l'assemblée générale annuelle.\" Adopté.Vraie copie d'un règlement adopté à une assemblée des directeurs de \"Montreal Cutting Company Limited\", tenue au bureau de la compagnie, le 22 octobre 1954, et approuvé à l'unanimité par tous les actionnaires réunis en assemblée ce même jour à midi.(Sceau) Le Secrétaire, 38960-o MARIE-PAULE DELISLE.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Marie Reine de la Paix\", under date of November 28th, 1954, whereof the head office is at Roxboro, in the county of Jacques-Cartier, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth day of December, 1954.JEAN BRUCHÊSI, 38946 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Forestier de Foumière\" under date December 6th, 1954, whereof the head office is at Malartic, in the county of Abitibi-East and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirtieth day of December, 1954.JEAN BRUCHÊSI, 3S951 Under Secretary of the Province.(A.G.4318-51) Amsel & Amsel Inc.By-law No.2b \"Upon motion duly made and seconded, the following resolution was unanimously adopted: Be it resolved: That By-law No.24 be and is herewith enacted increasing the number of Directors of the company from three to four Directors.\" Certified true copy.L.AMSEL, President.MOE AMSEL, 38959-0 Secretary-Treasurer.(A.G.3291-52) Montreal Cutting Company Limited By-law No.1^ (Concerning an increase in the number of directors from three (3) to fivc(5).\"The affairs of the company shall be managed by a Board composed of five directors to be elected for a period of orte year by the shareholders at the general annual meeting.\" Adopted.True copy of a by-law adopted at a meeting of directors of \"Montreal Cutting Company Limited\", held at the Company's office, on October 22nd, 1954, and unanimously approved by all shareholders convened at a meeting, this same day at noon.(Seal) MARIE PAU LE DELISLE, 38960 Secretary.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162, as added 6 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le dix-sept décembre 1954, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Syndicat Catholique des Employés de Pharmacies de Québec, Inc.\", dont la formation a été autorisée le 2 mars 1948, et le siège social, fixé à Québec, dans le district judiciaire de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le quatre janvier 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 38961-0 JEAN BRUCHÊSI.Canada, Province de Québec Ville de Beauport thereto by Act 11 George VI, chapter 52, section 5, the Honourable the Provincial Secretary has decreed, on December seventeenth 1954, the termination of the corporative existence of the professional syndicate \"Syndicat Catholique des Employés de Parmacies de Québec, Inc.\", the formation of which had been authorized on March 2nd, 1948, and the corporate seat fixed at Quebec, in the judicial district of Quebec.(îiven at the office of the Provincial Secretary, the fourth day of January, 1955.JEAN BRUCHÊSI, 38961 Under Secretary of the Province.Canada, Province of Quebec Town op Beauport Règlement N° 189 concernant l'élection générale By-Law No.189 concerning the General Election du maire et des échevins pour la ville de Beau- of the Mayor and Aldermen for the town of port.Beauport.Attendu que conformément à l'article 173-B de la Loi des Cités et Villes (chapitre 233 des Statuts refondus de Québec de 1941), tel qu'édicté par la loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 32, article 3, le conseil de la ville de Beauport a le pouvoir de changer la date des élections générales municipales en décrétant qu'elles auront lieu le premier jour juridique de novembre, au lieu du premier jour juridique de février; Attendu que ce changement est opportun, équitable et juste à bien des points de vue; Attendu que ce changement de date permettra la tenue de l'élection générale municipale à une période plus favorable de l'année; Attendu qu'en effet, le climat est moins rigoureux et la température généralement plus clémente au début de novembre qu'au début de février alors qu'à cette dernière époque il arrive qu'un froid rigoureux accompagné d'abondantes tempêtes de neige sévissent; Attendu que la circulation sur les routes est plus facile et plus sécuritaire au début de novembre, ce qui permettra un déplacement plus général des électeurs désireux d'exercer leur droit de vote; Attendu que les électeurs figés et malades pourront ainsi exercer leur droit de vote alors qu'un certain nombre d'entre eux en sont empêchés l'hiver; Attendu que dans l'intérêt de la bonne administration des affaires de la ville, il est préférable que les élus du peuple commencent leur terme d'office en temps pour pouvoir s'initier à l'administration, examiner la situation financière et préparer leur premier budget applicable à l'année fiscale commençant le 1er janvier suivant l'élection; Attendu que chaque administration entrant à l'Hôtel de Ville après une élection générale aura ainsi l'entière responsabilité des décisions fiscales, budgétaires et autres pour toute la durée de son terme d'office avec l'avantage de gouverner ainsi les affaires de la ville selon le mandat reçu des électeurs et pendant toute la durée du dit mandat; Attendu qu'il est à propos de décréter ce changement; Il est en conséquence ordonné et statué et le conseil de la ville de Beauport ordonne et statue par le présent règlement, ce qui suit, savoir; 1.la prochaine élection générale du maire et des échevins pour la ville de Beauport, dans le comté de Québec, aura lieu le premier jour Whereas, pursuant to article 173-B of the Cities and Towns Act (Chapter 233 of the Revised Statutes of Quebec of 1941), as enacted by the Act 2-3 Elizabeth II, Chapter 32, article 3, the Council of the Town of Beauport has the power to change the date of the municipal general elections by enacting that they shall take place on the first juridcial day of November, instead of the first juridical day of February; Whereas the change is opportune, fair and just from many points of view; Whereas this change of date shall allow the holding of a genral municipal election at a more favorable time of the year; Whereas indeed, the weather is not so harsh and the temperature is generally milder at the beginning of November than at the beginning of February, at which latter time of year, severe cold, accompanied by heavy snowstorms is rife; Whereas traffic on the highways is easier and safer at the beginning of November, which would allow for a greater displacement of electors desirous of excercising their right to vote; Whereas aged and sick electors may also carry out their rihgt to vote when a certain number of them are prevented from doing so in winter; Whereas in the interest of the good administration of the affairs of the town, it is preferable that the elected candidates start their term of office in sufficient time to become initiated into the administration, to examine the financial situation and to prepare their first budget to be applicable to the fiscal year starting January 1st, following the election; Whereas each administration which enters the Town Hall after a general election will, in this way, have the entire responsibility of fiscal, budgetary and other decisions for the duration of its term of office with the advantage of so governing the affairs of the town according to the mandate received by the electors and for the duration of the said mandate; Whereas it is deemed advisable to enact this change; Therefore it is ordained and decreed that the Council of the Town of Beauport ordains and decrees by the present By-law the following, to wit: 1.the next general election of the Mayor and Aldermen for the Town of Beauport, in the county of Quebec, shall take place on the firs! QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 7 juridique de novembre 1955, au lieu du 1er jour juridique de février 1950.2.par la suite, toute élection générale du maire et des échevins pour la ville de Beauport, dans le comté de Québec, devra être tenue le premier jour juridique du mois de novembre de toute année, dans laquelle doit être tenue une élection générale suivant la loi, la charte de la ville et les règlements alors en vigueur.3.le présent règlement, après son approbation ¦ par le Ministre des Affaires Municipales et sa publication dans la Gazette officielle de Québec, entrera en vigueur suivant la loi.Fait et passé en la Ville de Beauport, ce Gième jour de Décembre 1954.Copie conforme.Le Maire, J.ULYSSE STE-MARIE.Le Secrétaire-trésorier, 38963-0 GEORGES E.BOUÏET.Chartes \u2014 Abandon de Building Renovators Development, Inc.AVIS Avis est par les présentes donné que \"Building Renovators Development, Inc.\", corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant sa place d'affaires en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur Général de la province de Québec, pour obtenir l'abandon de sa charte en vertu des dispositions de la Loi des Companies de Québec.Daté à Montréal, ce 29c jour de décembre 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 38940-o MAURICE TRUDEAU.A qui de droit: Avis est donné par les présentes que la compagnie \"Ross & Frères Ltée\", demandera l'abandon de sa charte.Matane, 18 décembre 1954.Ross & Frères Limitée, Par le Président, 3894 l-o DANIEL ROSS./ Avis est par les présentes donné que la compagnie dite \"Macon Investments Limited\" constitué en corporation par lettres patentes de la province de Québec en date du 6 novembre, 1946, demandera la permission.d'abandonner sa charte.Montréal, le 3 janvier 1955.Les Procureureurs de la compagnie dite Macon Investments Limited, 38948-0 GENSER & PHILLIPS.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Bernstein Bros.Ltd.\" se propose de demander au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 24 décembre 1954.juridical day of November, 1955, instead of on the first juridical day of February, 1956.2.following which, any general election for the Mayor and the Aldermen for the Town of Beauport, in the county of Quebec, shall be held on the first juridical day of the month of November of any year in which is to be held a general election, according to Law, the Charter of the Town and the By-laws then in force.3.the present By-law, after its approbation by the Minister of Municipal Affairs and its publication in the Quebec Official Gazette, shall enter into force according to Law.Made and Passed in the Town of Beauport, this sixth day of December, 1954.True copy.J.ULYSSE STE-MARIE, Mayor.GEORGES E.BOUTET, 38963 Secretary -Treasu rer.Charters \u2014 Surrender of Building Renovators Development, Inc.NOTICE Notice is hereby given that \"Building Renovators Development, Inc.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 29th day of December, 1954.(Seal) MAURICE TRUDEAU, 38940-o Secretary.To whom it may concern: Notice is given by these presents that the company \"Ross & Frères Ltée\" will ask for the surrender of its charter.Matane, December 18th, 1954.Ross & Frères Limitée, DANIEL ROSS, 38941 President.Notice is hereby given that \"Macom Investments Limited\" incorporated by letters patent of the Province of Quebec, dated November 6th, 1946, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, January 3rd, 1955.GENSER & PHILLIPS, Attorneys for 3S948-0 Macon Investments Limited.Notice is hereby given under the Quebec Companies' Act, that \"Bernstein Bros.Ltd.\" intends to apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter.\u2014\" Montreal, December 24th, 1954.Le Procureur de la'rcquérante, .BEN BERNSTEIN, 38949 BEN BERNSTEIN.3S949-0 Attorney for the petitioner. s GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 Demandes à la Législature AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la \"Commission des Écoles catholiques de Montréal\" demandera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi en vue d'accroître les pouvoirs de la Commission ayant trait à l'établissement ou à la modification d'assurances collectives ou autres en faveur de certaines personnes; d'amender les dispositions de sa charte relatives à son fonds de dotation; de modifier les dispositions de sa charte ayant trait au fonds de pension de ses employés; de déterminer la mise en vigueur de certains règlements municipaux à l'égard de la construction des écoles; d'autoriser, pour les fins de la taxe scolaire, l'inscription des mutations de propriétés au rôle de la cité de Montréal; et pour d'autres fins.Montréal, ce 10 décembre 1954.Le Procureur de la Commission des Écoles Catholiques de Montréal, 38829-51-4-0 GASTON POULIOT.Cité de Hull Avis est, par les présentes, donné que la \"cité de Hull\", s'adressera à la Législature de la Province de Québec, lors de sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale, amendant sa charte, pour les fins suivantes: pour permettre l'amendement de son règlement de construction et de zonage sans referendum populaire durant sa première année d'existence; pour accorder des subventions dans certains cas particuliers; pour acquérir des immeubles pour fins industrielles; et pour d'autres fins.Hull, le 7 décembre 1954.Le Maire, (Signé) ALEXIS CARON.IiC Greffier (Signé) H.LÉON LEBLANC.Contresigné: Le Procureur de la cité de Hull, 38830-51-4-o ROY FOURNIER.AVIS DE PÉTITION Avis est par les présentes donné que la cité de Rivière-du-Loup demandera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi amendant sa charte pour les fins suivantes: pour l'autoriser à emprunter une somme d'environ S300.000.et à prêter le produit de cet emprunt à une compagnie de distribution d'énergie électrique, pour permettre à cette compagnie de construire une ligne de transmission électrique d'un point quelconque où se termine le réseau de cette compagnie jusqu'à la centrale électrique de la cité.Rivière-du-Loup, ce 15 décembre 1954.Le Procureur de la Cité de Rivière-du-Loup, 38884-52-4-o , JEAN-PAUL BÉRUBÉ, AVIS Avis par les présentes est donné que les Commissaires d'Écoles pour la municipalité scolaire du village de Cap Chat, et les Commissaires d'Écoles pour la municipalité scolaire de Ste-Anne des Monts village, s'adresseront à la Légis- Applications to Legislature PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the \"Montreal Catholic School Commission\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act to increase the powers of the Commission concerning the establishment and the modification of group insurances or other insurances in favour of certain people; to amend the provisions of its charter concerning its endowment fund; to modify the provisions of its.charter concerning the pension fund for its employees; to determine the coming into force of the municipal building by-laws'with respect to the erection of schools; for the purpose of the school tax to authorize the inscription of the changes of ownership on the roll of the city of Montreal; and for other purposes.Montreal, December 10th, 1954.GASTON POULIOT, Attorney for the Montreal 38829-51-4-0 Catholic School Commission.City of Hull Notice is hereby given that the \"city of Hull\" will present a petition to the Legislature of the Province of Quebec, at is present session, to obtain the adoption of a special law, amending its charter, for the following purposes: to amend its building and zoning by-law without public referendum during its first year of existence; to make grants in certain cases; to acquire immovables for industrial purposes; and for other purposes.Hull, December 7th, 1954.(Signed) ALEXIS CARON, Mayor.(Signed) H.LÉON LEBLANC, City Clerk.\u2022 Contersigned: ROY FOURNIER, 38830-51-4-o Attorney for the city of Hull.NOTICE OF PETITION Notice is hereby given that the city of Rivière-du-Loup will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter for the following purposes: to authorize the city to borrow a sum of about $300,000 and to loan the proceeds of this transaction to an electric distribution company, in order that said company be permitted to construct an electric power line connecting the Company's system with the city's municipal electric power plant.Rivière du Loup, this December 15th, 1954.JEAN-PAUL BÉRUBÉ, Attorney for the City 38884-52-4 of Rivière-du-Loup NOTICE Notice is hereby given that the School Commissioners for the School Municipality of the village of Cap Chat, and the School Commissioners for the School municipality of St.Anne des Monts village, will apply to the Legislature QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 9 lature de la province de Québec, à la présente session, pour obtenir la passation d'une Loi les autorisant à imposer une taxe spéciale de vente de 2%, dans leur territoire respectif.La commission scolaire du village de Cap Chat.Par le Secrétaire-trésorier, FRANÇOIS GAGNON.La Commission scolaire de Ste-Anne des Monts village.Par le Secrétaire-trésorier, LOUIS-PHILIPPE LANGEHER.38850-51-4-o AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Dorval, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la Loi 14 George VI, chapitre 120, en sus des matières décrites à l'avis du 22 novembre 1954, sur les matières suivantes: annexion du territoire de la corporation municipale de la paroisse de Côte de Liesse; et pour autres fins.Montréal, le 22 décembre 1954.Les Procureurs de la Ville de Dorval, LACROIX, VIAU & POUPART.38917-53-4-6 AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Pointe-Claire s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi, amendant sa charte, la loi 1 George V, chapitre 71, en sus des matières décrites à l'avis du 3 novembre 1954, sur les matières suivantes: imposer une taxe de vente de 2% pour fins municipales; et pour autres fins.Montréal, le 23 décembre 1954.Les Procureurs de la Ville de Pointe-Claire, LACROIX, VIAU & POUPART.38918-53-4-0 AVIS PUBLIC \u2022 Avis public est présentement donné qu'Irving-Louis Paul, rentier, ci-devant de Montréal, résidant actuellement à Miami-Beach, dans l'Etat de Floride, Sydney Paul, administrateur, de Flushing, Barnet Puttcrman, comptable, tous deux des ville et État de New York, et Samuel Paul, administrateur de la ville de Kansas, État de Missouri, tous des États-Unis d'Amérique, pétitionneront les Corps législatifs de la province de Québec, à leur présente session, pour l'adoption d'une loi validant un accord intervenu le 22 décembre 1954 entre les pétitionnaires, l'épouse dudit Irving-Louis Paul (née Marleau) et les bénéficiaires et fiduciaires de celui-ci, par-devant Me J.-Barrie Campbell.Montréal, le 31 décembre 1954.Les Avocats des pétitionnaires, VICTOR PAGER et LOUIS-JOSEPH 38953-1-4-Q \u2022 DE LA DURANTAYE Département de l'Instruction Publique N° 949-54.Québec, le 9 décembre 1954.' Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Jcanne-d'Arc, dans le of the province of Quebec, at its present session, to obtain the passing of an Act authorizing them to impose a special sales tax of 2%, in their respective territories.The School Commission of the village of Cap Chat, Per: FRANÇOIS GAGNON, Secretary-Treasurer.The School Commission of St.Anne des Monts village, Per: LOUIS-PHILIPPE LANGELIER, Secretary-Treasurer.38850-51-4 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Dorval will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 14 George VI, chapter 120, in addition to the purposes described in the notice of November 22th, 1954, for the following purposes: annexation of the territory of the municipal corporation of the parish of Côte de Liesse; and for other purposes.Montreal, December 22nd.1954.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys for the Town of Dorval.38917-53-4-0 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Pointe-Claire will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 1 George V, chapter 71, in addition to the purposes described in the notice of November 3rd, 1954, for the following purposes: to impose a 2% tax for municipal purposes; and for other purposes.Montreal, December 23rd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys for the Town of Pointe-Claire.38918-53-4-0 PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that Irving-Louis Paul, gentleman, formerly of the city of Montreal, now residing at Miami Beach, in the State of Florida, Sydney Paid, business executive, of Flushing, Barnet Putterman, accountant, both of the city and State of New-York, and Samuel Paul, business executive, of the city of Kansas in the State of Missouri, all of the United States of America, will petition the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an Act validating an agreement passed on the 22nd of December 1954, between them, the wife of the said Irving-Louis Paul (née Marleau) and his beneficiaries and trustees, before Me J.-Barrie Campbell.Montreal, December 31st, 1954.VICTOR PAGER and LOUIS-JOSEPH DE LA DURANTAYE, 3S953-1-4-0 Attorneys for the petitioners.Department of Education No.949-54.Quebec, December 9th, 1954.Application is made to detach from the School Municipality of St.Jcanne-d'Arc, in the county 10 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 comté de Matapédia, le lot N° 56 du rang I du canton Cabot pour l'annexer à la municipalité scolaire de La Rédemption, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38934-1-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1339-52.Québec, le 9 décembre 1954.Demande est faite que le territoire actuel de la municipalité scolaire du village de Ste-Jeanne-d'Arc, dans le comté d'Abitibi-ouest, soit annexé à celui de la municipalité scolaire de la paroisse de Ste-Jeannc-d'Arc, dans le môme comté.Le territoire qu'il s'agit d'annexer, comprend les lots 16 à 31 inclusivement des rangs II et III du canton La Reine.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38935-1-2-0 0.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de S-Joachim-de-Cliâtcauguay, division d'enregistrement de Châteauguay.Avis est par la présente donné que les lots 111-1-1, 111-1-2, 111-2-1, 111-2-2, 111-3-1, 111-3-2, 111-4-1, 111-4-2, 111-6-1, 111-6-2, 111-7-1, 111-7-2, 111-8-1, 111-8-2, 111-9-1, 111-9-2 et 111-1 à 111-14 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 décembre 1954.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 38937-Q A VILA BÉDARD.of Matapédia, lot No.56, range I, of the township of Cabot in order that it be annexed to the School Municipality of La Rédemption, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38934-1-2 Superintendent of Education.No.1339-52.Quebec, December 9th, 1954.Application is made that the present territory of the School Municipality of the village of St.Jeanne-d'Arc, in the county of Abitibi-west, be annexed to that the School Municipality of the parish of St.Jeanne-d'Arc, in the same county.The territory to be annexed includes lots 16 to 31 inclusive, of ranges II and III, township of La Reine.O.J.DÉSAULNIERS, 38935-1-2 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of St.Joachim-de-Châteauguay, registration division of Châteauguay.Notice is hereby given that lots 111-1-1, 111-1-2, 111-2-1, 111-2-2, 111-34 111-3-2, 111-4-1, 111-4-2, 111-6-1, 111-6-2, 111-7-1, 111-7-2, 111-8-1, 111-8-2, 111-9-1, 111-9-2 and 111-1 to 111-14 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, December 28th, 1954.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 38937-0 Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire des métiers du bâtiment du district des Trois-Rivières lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et ii la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 256 du 5 mars 1953 et amendements, relatif à liindustric de la construction dans la région des Trois-Rivières: Les mots \"installations électriques de tous genres assujetties à la Loi des électriciens et des installations électriques\" seront ajoutés avant les mots \"installation des tours de transmission d'énergie électrique\" apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article III (Juridiction Industrielle).Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, G ÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 8 janvier 1955.3S957-o Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of the Building Trades of the district of Trois-Rivières has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree No.256 of March 5th, 1953, and amendments, relating to the construction industry in the district of Trois-Rivières: The words \"and to the installation of eleclric transmission towers\", mentioned in the first paragraph of subsection \"a\" of section III, will be replaced by the following: \"and to electrical installations of all kinds subject to the Electricians and Electrical Installations Act, to the installation of electric transmission towers\".During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour,\" Quebec, January 8th, 1955.38957 -o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 11 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du meuble dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 505 du 7 mai 1952 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret, savoir: 1° Que dans le préambule, en dessous de \"Et, d'autre part\", \"La Fédéradion nationale du Meuble Inc.\" soit biffée et remplacée par: La Fédération des Travailleurs du Bois Ouvré du Canada.2° Que l'Article II.\u2014 Juridiction Industrielle, soit complètement biffé et remplacé par le suivant: II.\u2014 Juridiction Industrielle: La juridiction industrielle du décret comprend la fabrication de tout ameublement de maison ou tout ameublement commercial, accessoires et composants, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance, à l'exception des meubles faits exclusivement de métal, en particulier: (L'énumération des articles suivants est énon-ciative et non limitative).a) Tout ameublement de salle à dîner incluant cabinets à argenterie, cabinets de coin, chaises, tables, tables à extension, tables à service, wagonnets à thé, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.b) Tout ameublement de chambre à coucher incluant lits en bois, lits pliants, lits d'enfants, bureaux, coiffeuses, chiffonniers, commodes, coffres, costumiers, tables de toilette, tables de nuit, chaises, garde-robes et toute combinaison des articles ci-dessus, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.c) Tout ameublement de cuisine et de salle à déjeuner incluant buffets, cabinets, bases, chaises, armoires et armoires préfabriquées, petits bancs, tabourets, escabeaux, planches à repasser, tables, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.d) Tout ameublement de maison non énumé-ré dans \"a\", \"6\" et \"c\", incluant bancs, bibliothèques et étagères, cabinets de téléphone, cabinets de couture et de machine à coudre, cabinets de fumeurs, cabinets à liqueurs, chaises, bureaux et secrétaires, nouveautés et cadeaux, fougeraies, étagères à magazines, piédestaux, étagères à livres, jardinières, porte-parapluies, tabagies et les tables de tous genres, cabinets de radio et de télévision, pianos, orgues de maison à harmoniums, cabinets de mur et de coin, cabinets de musique, cabinets pour gramophones et disques, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.e) Tout ameublement de bureau incluant cabinets, armoires, chaises, pupitres, tables, pa-tères, paniers à papier, plateaux, bibliothèques, étagères, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance./) Tout ameublement d'école incluant pupitres, chaises, chaises pliantes, tables, bibliothèques, étagères, ameublement de laboratoire, de NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the collective agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 103 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the furniture industry in the Province of Quebec, rendered obligatory by the decree No.505 of May 7th, 1952 and amendments, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree, to wit: 1.That in the preamble, a) after \"Whereas the contracting parties hereafter mentioned\", the word \"have\" be substituted to \"are\", in the english version only.b) after \"And, ox the other part:\", \"La Federation des Travailleurs du Bois Ouvré du Canada\" be substituted to \"La Fédération nationale du Meuble Inc.\".2.That Article II.\u2014 Industrial Jurisdiction, be completely deleted and replaced by the following: II.\u2014 Industrial Jurisdiction: The industrial jurisdiction of the decree comprises the manufacturing of ail household furniture and commercial furniture, accessory and component parts made of wood or combination of wood and any other material (excepting all metal furniture) as follows: (The following enumeration is enunci itive an I not limitative).a) All dining room furniture including buffets, silverware or china (cabinets, corner cupboards, chairs, tables, extension tables, serving tables, tea wagons, made of wood or combination of wood and any other material.b) All bedroom furniture, including wooden beds, folding beds, children's beds, cots and cribs, dressers, chiffoniers, vanities, chest of drawers, chests, costumers, (1res ing tables, night tables, commodes, benches, chairs, wardrobes and any combination of the above articles, made of wood or combination of wood and any other material.c) All kitchen and breakfast room furniture including buffets, cabinets,' bases, chairs, cupboards end prefabricated 'cupboards, stools, step-ladders, ironing boards, tables, made of wood or combination of wood and any other material.d) All household furniture not enumerated in \"«\", \"b\" and \"c\".including benches, bookcases and book racks, telephone cabinets, sewing and sewing machine cabinets, smokers cabinets, cellarets, chairs, desks and secretaries, novelty and gift furniture, ferneries, magazine racks, pedestals, book stands, flower stands, umbralla stands, smoker's sets and tables of all descriptions, radio and television cabinets, pianos, house organs and harmoniums, wall and coiner cabinets, music cabinets, gramophone and record cabinets, made of wood or combination of wood and any other material.e) All office furniture including cabinets, cupboards, chairs, desks, tables, coat and hat racks, waste baskets,.trays, bookcases, stands, made of wood or combination of wood and any other material./) All school furniture including desks, chairs, folding chairs, tables, bookcases, stands.laboratory, domestic science, manual training, furniture 12 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 salles de science domestique, d'entraînement manuel, meubles et objets d'art, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.g) Tous bancs, chaises ou tables pour pelouses, parcs, porches et tout meuble d'été, incluant l'équipement pour terrains de jeux, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.h) Tous meubles divers incluant meubles pour enfants, sets de table et chaises pour enfants, paniers à linge, pharmacies, lampes de table et de plancher, cendriers en bois sur pied et fumoirs, bibliothèques et étagères, coffres de cèdre, charpentes seulement de \"'chesterfield\", de sets de studio ou de tous les autres articles rembourrés, pièces de meubles entièrement ou partiellement fabriquées, telles que dessus de meubles et devants de tiroirs fabriqués spécialement pour l'assemblage d'un article d'ameublement complet, faits de bois ou mélange de bois et de toute autre substance.i) Tout ameublement préfabriqué fait de bois ou mélange de bois et de toute autre substance pour églises, hôpitaux, hôtels, salles publiques, clubs, restaurants, tavernes, maisons et magasins, incluant tout article énuméré dans les paragraphes précédents.3° Que l'Article III.\u2014 Taux minima des salaires (parties I et II), soit complètement biffé et remplacé par le suivant: III.\u2014 Taux minima des salaires: Les taux de salaires minima des salariés, y compris les membres du personnel féminin, travaillant à la fabrication ou réparation des meubles ou autres articles inclus dans la juridiction industrielle du présent décret, de même que celui des chauffeurs de bouilloires, des gardiens-chauffeurs de bouilloires, des mécaniciens de machines fixes, des gardiens, des préposés à l'expédition, des préposés au transport, des préposés à l'entretien ou à la réparation des machines et immeubles, sont les suivants: Zone I: Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à S0.95 de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (primes pour temps supplémentaire étant exclues) est divisé par le total des heures de travail.Les salaires de chaque salarié assujetti au décret sont inclus dans la computation de telle moyenne, excepté celui de toute personne occupant une position supérieure à celle de contremaître.Les salaires minima sont déterminés comme suit: de l'heure Salariés de moins de 18 ans.SO.55 Salariés de 18 ans et plus: Premier trimestre.0.60 Deuxième trimestre.0.65 Après le premier semestre.0.70 Après un an.0.75 Après deux ans.;.0.80 Lés salaires minima suivants s'appliquent aux gardiens seulement: Première année.SO.70 Après un an.0.75 Zone II: Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à S0.85 de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (primes pour temps supplémentaire étant exclues) est divisé par le total des heures de travail.Les salaires de chaque salarié assujetti au décret sont inclus dans la computation de telle moyenne, excepté celui de toute personne occupant une position supérieure à celle de contremaître.Les salaires minima sont déterminés comme suit:' de Theure Salariés de moins de 18 ans.\u2022.S0.51 Salariés de 18 ans et plus: Premier trimestre.0.56 and art objects, made of wood or combination of wood and any other material.g) All lawn, porch, park and summer furniture including chairs, tables, benches, playground equipment, made of wood or combination of wood and any other material.h) All miscellaneous furniture including juvenile furniture, kindergarten table and chairs sets, hampers, médecine chests, table and floor lamps, wooden ash stands and smokers, bookcases and stands, cedar chests, frames only of chesterfields, studio sets, and all other upholstered furniture, furniture parts entirely or partially manufactured, such as as shaped tops, drawer fronts manufactured specifically jor incorporating into a complete article of furniture, made of wood or combination of wood and any other material.' i) All prefabricated furniture made of wood or combination of wood and any other material for churches, hospitals, hotels, public halls, clubs, restaurants, taverns, households and stores, including all articles enumerated in the preceding subsections.3.That Article III.\u2014 Minimum rates of wages (Part I and Part II), be completely deleted and replaced by the following: III.\u2014.Minimum rates of wages: The minimum rates of wages of the employees, including the members of the female staff, working at manufacturing or repairing of furniture or other articles included in the industrial jurisdiction of the present decree, and those of boiler firemen, watchmen firemen, stationary enginemen, watchmen and men committed to shipping, transportation and to the maintenance or repair of machines and buildings shall be the following: Zone I: The average wage shall not be less than S0.95 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be divided by the total of the hours worked.The wages of every employee subject to the decree shall be included in such average, except that of any person holding a position above the rank of foreman.The minimum wages are as follows: per hour Employees of less than 18 years of age.$0.55 Employees of 18 years of age and over: First three months.0.60 Second three months.0.65 After six months.0.70 After one year.\u201e.0.75 After two years.0.80 The following minimum rates apply to watchmen only: First y ear.SO.70 After one year.0.75 Zone II: The average wage shall not be less than S0.85 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be divided by the total of the hours worked.The wages of every employee subject to the decree shall be included in such average, except that of any person holding a position above the rank of foreman.The minimum wages are as follows: per hour Employees of less than 18 years of age.$0.51 Employees of 18 years of age and over: First three months.0.56 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol, 87, No.1 13 Deuxième trimestre.0.60 Après le premier semestre.0.65 Après un an.0.70 Après deux ans.\".0.74 Les salaires minima suivants s'appliquent aux gardiens seulement: Première année.$0.65 Après un an.0.70 Zone III: Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 80.75 de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (primes pour temps supplémentaire étant exclues) est divisé par le total des heures de travail.Les salaires de chaque salarié assujetti au décret sont inclus dans la computation de telle moyenne, excepté celui de toute personne occupant une position supérieure à celle de contremaître.Les salaires minima sont déterminés comme suit: « de l'heure Salariés de moins de 18 ans.$0.47 Salariés de 18 ans et plus: Premier trimestre.S0.51 Deuxième trimestre.0.54 Après le premier semestre.0.58 Après un an.0.62 Après deux ans.0.05 Les salaires minima suivants s'appliquent aux gardiens seulement: Première année.$0.58 Après un an.0.02 La durée de service dans l'industrie du meuble en général doit déterminer les taux minima ci-dessus pour fin d'application immédiate.Dès le moment où un salarié atteint l'âge de dix-huit ans, il doit être tenu compte dans la détermination de son salaire minimum, de la durée de son service dans l'industrie du meuble avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans.Les augmentations de salaires que tout employeur doit accorder pour atteindre la moyenne de sa zone, doivent être réparties également, d'une manière uniforme, parmi tous les salariés.Si pendant la durée du présent décret le Comité paritaire de l'Industrie du Meuble doit faire des réclamations de salaires parce que la moyenne minimum n'a pas été observée, les montants ainsi réclamés doivent être distribués par le Comité paritaire à tous les salariés rapportés durant cette période, .proportionnellement aux heures de travail accomplies durant ladite période.Pour fins de calcul de la moyenne des salaires prévue au présent article, tous salaires du ou des propriétaires des industries soumises aux dispositions du présent décret, et dans le cas d'une compagnie limitée ou incorporée, tous salaires des membres du conseil d'administration ne peuvent être compris dans la computation d'une telle moyenne.4° Que l'Article IV soit complètement biffé et remplacé par le suivant: IV.\u2014 Rien dans la présente convention collective ne peut en aucun cas ou temps permettre la réduction des taux de salaires payés soit à l'heure, soit à la pièce.- 5° Que l'Article V.\u2014 Semaine de travail et temps supplémentaire: Zones I, II et III, soit complètement biffé et remplacé par le suivant: V.\u2014 Semaine de travail et temps supplémentaire: Zones I, II et III: a) La semaine régulière de travail dans les zones I, II et III ne doit pas dépasser quarante-huit (48) heures, soit pas plus que neuf (9) heures par jour du lundi au vendredi inclusivement, et pas plus que cinq (5) heures le samedi.Second three months.0.60 After six months.0.65 After one year.0.70 After two years.0.74 The following minimum rates apply to watchmen only: First year.$0.65 After one year.1.0.70 Zone III: The average wage shall not be less than S0.75 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be divided by the total of the hours worked.The wages of every employees subject to the decree shall be included in such average, except that of any person holding a position above the rank of foreman.The minimum wages are as follows: per hour Employees of less than 18 years of age.$0.47 Employees of 18 years of age and over: First three months.0.51 Second three months.0.54 After six months.0.58 After one year.0.62 After two years.0.05 The following minimum rates apply to watchmen only: First year.$0.58 After one year.0.62 The lenght of service in the furniture industry in general shall determine the minimum hourly rates provided for herein above for immediate application.As soon as an employees attains the age of eighteen years, the lenght of his service in the furniture industry before attaining that age, shall be taken into account in determining his minimum salary.The increases in wages that any employer shall have to grant in order to reach the average for his zone, shall be distributed equally, in a uniform manner, amongst all the employees.If, during the existence of the present decree, the Joint Committee of the Furniture Industry has to file claims for wages because the minimum average has not been observed, the amounts thus claimed shall be distributed by the Joint Committee to all employees reported during this period, prorata to hours worked during this said period.For the purposes of computing average wages provided for under the present section, all wages of the owner or owners of industries governed by the provisions of the present decree and, in the case of a limited or incorporated company, all wages of the members of the Board of Directors shall not be included in the computation of such average.4.That Article IV be completely deleted and replaced by the following: IV.\u2014 Nothing in the present collective agreement shall, in any event or at any time, permit the reduction of the present wage rates paid, either by the hour or for piece-work.5.That Article V, Regular working week and overtime: Zones I, II and III, be completely deleted and replaced by the following: V.\u2014 Regular working week and overtime: Zones I, and III: a) The regular working week in zones IVJ[I and III shall not exceed forty-eight (4^ho4uj£> that is not more than nine (9) hours-p\"e^l'ûylfW^.Monday to Friday inclusively, and ijSoi more than five (5) hours on Saturday.All ^r^^|$tfft$fc 14 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 Tout travail exécuté en dehors des heures régulières mentionnées dans le présent paragraphe doit être rémunéré au taux de salaire et demi./;) Le travail, durant la semaine régulière ci-haut décrite, doit être exécuté entre 7.00 a.m.et 0.00 p.m.du lundi au vendredi inclusivement, et entre 7.00 a.m.et midi le samedi.Tout travail exécuté en dehors des heures régulières mentionnées dans le présent paragraphe doit être rémunéré au taux de salaire et demi.c) Nonobstant, le paragraphe précédent .concernant les heures de travail, à la suite d'une entente entre employeurs et salariés, les heures de travail peuvent-être de 7.00 a.m.à 0.00 p.m.du lundi au vendredi inclusivement, n'excédant pas dix (10) heures par jour, formant un total maximum de quarante-huit (4S) heures par semain-ne, dans lequel cas il n'y a pas de travail le samedi.Tout travail exécuté en dehors des heures régulières mentionnées dans le présent paragraphe doit être rémunéré au taux de salaire et demi.d) Nonobstant les paragraphes \"a\", \"b\" et \"c\", l'employeur peut mettre en vigueur un régime d'équipes additionnelles dont la semaine régulière de travail ne doit pas dépasser celle de l'équipe régulière prévue aux paragraphes \"a\" ou \"c\" du présent article, selon le cas, après quoi la règle de temps supplémentaire s'applique.Les salariés faisant partie de telles équipes additionnelles doivent recevoir une prime de cinq cents (S05) l'heure.e) Nonobstant ce qui précède, l'employeur a le droit d'employer une équipe régulière de nuit, entre 7.00 p.m.et 0.00 a.m., sauf le samedi et le dimanche.Tout travail exécuté en dehors des heures régulières mentionnées dans le présent paragraphe doit être rémunéré au taux de salaire et demi./) La semaine régulière de travail des préposés à l'expédition, à l'entretien et à la réparation, ne doit pas dépasser quarante-huit (48) heures et la journée régulière de travail ne doit pas dépasser dix (10) heures, sans restriction quant à l'heure du début et de la fin du travail.Tout travail exécuté en dehors des heures régulières mentionnées dans le présent paragraphe doit être rémunéré au taux de salaire et demi.g) La semaine régulière des chauffeurs de bouilloires et des mécaniciens de machines fixes ne doit pas dépasser cinquante-six (50) heures, sans autre restriction.Tout travail exécuté après cinquante-six (50) heures doit être rémuné-\u2022ré au taux de salaire et demi* h) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux gardiens, aux chauffeurs de camions et aides, aux préposés aux camions, aux conducteurs de voitures à traction animale et aides.6° Que l'article VI.\u2014 Dimanches et jours fêtes, soit complètement biffé et remplacé par le suivant: VI.\u2014 Dimanches et jours de fêtes: a) Dans les zones I, II et III, tout travail exécuté le dimanche, le Premier de l'An, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, la Toussaint, ITmmaculée-Conception et le Jour de Noël, doit être rémunéré au taux de salaire double.Après entente entre l'employeur et les employés concernés, il est permis de remplacer le temps perdu à cause de chômage la journée de travail immédiatement précédente ou suivante des fêtes mentionnées dans le paragraphe \"a\" de cet article, par un nombre équivalent d'heures de after the regular hours mentioned in the present paragraph shall be remunerated at the rate of time and a half.b) During the regular working week described above, work shall be performed between 7.00 a.m.and 0.00 p.m.from Monday to Friday inclusively, and between 7.00 a.m.and 12 o'clock noon on Saturday.All work performed after the regular hours mentioned in the present paragraph shall be remunerated at the rate of time and a half.c) Notwithstanding the preceding subsection regarding the hours of work, by agreement between employers and employees, the hours of work may be from 7.00 a.m.to 0.00 p.m.from Monday to Friday inclusively, and not exceeding ten (10) hours per day, making a maximum total of forty-eight (48) hours per week, in which case there shall be no work on Saturday.All work performed after the regular hours mentioned in the present paragraph shall be remunerated at the rate of time and a half.d) Notwithstanding paragraphs \"a\", \"6\" and \"c\", the employer may set up a multiple shifts system with regular work week not exceeding that of the regular shift as provided in subsections \"a\" or \"c\" of the present section, whichever applies, and beyond which overtime rates shall apply.The employees in additional shifts shall receive a premium of five cents ($0.05) per hour.e) Notwithstanding the foregoing, the employer has the right to employ a regular night shift, between seven (7.00) p.m.and six (6.00) a.m.\u2022except on Saturday and Sunday.All work performed after the regular hours.mentioned in the present paragraph shall be remunerated at the rate of time and a half./) The regular work week for employees committed to shipping, maintenance and repairs shall not exceed forty-eight (48) hours and the regular working day shall not exceed ten (10) hours, without restriction as to starting and finishing time.All work performed after the regular hours mentioned in the present paragraph shall be remunerated at the rate of time and a half.g) The regular working week for firemen and stationary engincmcn shall not exceed fifty-six (50) hours, without any other restriction.Any work performed in excess of fifty-six (50) hours shall be remunerated at the rate of time and a half.h) The foregoing provisions do not apply to watchmen, truckdrivers and their helpers, truckmen (préposés aux camions) nor to horse-drawn vehicle drivers and their helpers.G.That Article VI.\u2014 Sundays and holidays, be completely deleted and replaced by the following: VI.\u2014 Sundays and holidays: a) In zones I, II and-III, all work performed on Sundays, New Year's Day, Epiphany Day, Good Friday, Ascension Day, St.John the Bap- , tist Day, Confederation Day, Labour Day, All Saints' Day, Immaculate Conception Day and Christmas Day shall be remunerated at the rate of double time.After an agreement between the employer and the employees concerned, it is permitted to replace the time lost on the working day immediately preceding or following the holidays mentioned in paragraph \"a\" of this article, by an equi- * valent number of working hours remunerated at r QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 16 travail rémunérées au taux régulier, au cours d'un ou de plusieurs jours convenus mutuellement, avec l'approbation préalable du Comité paritaire.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas cependant aux chauffeurs de bouilloires, gardiens-chauffeurs de bouilloires, mécaniciens de machines fixes, de même qu'aux gardiens.b) La fête du Travail, le Jour de Noël et le Premier de l'An, sont des jours chômés et payés dans les zones I, II et III.c) Pour qu'un employé bénéficie des congés payés prévus au décret, il doit travailler la journée de travail immédiatement précédente et la journée de travail immédiatement suivante de tel congé ou congés, à moins qu'il donne une excuse convenable à son employeur ou (pie celui-ci lui permettre de s'absenter.d) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans lé cas où les parties ont déjà convenu, par une convention collective particulière, de trois (3) jours ou plus, payés et chômés, et ce, pour la durée de cette convention.7° Que l'Article VII-A soit complètement biffé.8° Que l'Article IX.\u2014 Paiement du salaire, soit complètement biffé et remplacé par le suivant: IX.\u2014 Paiement du salaire: Le montant total de la paie, le nombre d'heures exécutées, le temps supplémentaire et le taux horaire doivent être inscrits sur l'enveloppe de paie.9° Que l'Article X.\u2014 Congés annuels payés, soit complètement biffé et remplacé par le suivant: X.\u2014 Congés annuels payés: Tout salarié assujetti au décret a droit à des congés payés conformément aux dispositions suivantes: 1) Après un an de service continu pour son employeur, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum de sept jours; et s'il n'a pas un an de service continu pour son employeur, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum d'autant de demi-jours qu'il a de mois de calendrier de service continu pour son employeur.2) Période de service continu donnant droit au congé: Pour chaque congé annuel payé, la période de service continu pour un employeur donnant droit à tel congé, s'établit du premier juin d'une année au trente et un mai de l'année subséquente.3) Services continus: La durée des services continus doit s'étendre de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait résiliation de contrat.Ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée des services continus, les jours de maladie, si le contrat n'a pas été résilié, les jours de fermeture,' les périodes de congé annuel, le délai-congé, les absences autorisées, si le travailleur n'a pas occupé pendant ces journées un autre emploi rémunéré.Dans la durée des services, les mois de calendrier durant lesquels un salarié n'a pas en fait travaillé quoiqu'il n'y ait pas eu résiliation de son contrat de travail, ne sauraient être comptés.the regular rate, during one or many days mutually agreed, with the previous approbation of the Joint Committee.The provisions of the present article do not apply to boiler firemen, watchmen-boiler firemen, stationary enginemcn or watchmen.b).Labour Day, Christmas Day and New Year's Day shall be Statutory Holidays with pay in zones I, II and III.c) For an employee to benefit from paid holidays set forth in the Decree, he must be at work on the working day immediately preceding and the working day immediately following such holiday or holidays, unless he offers a reasonable excuse to his employer or is absent because of permission granted by his employer.(/) The provisions of the present article do not apply in any case where the parties have already agreed on three (3) or more Statutory Holidays with pay in a particular collective agreement, this exception to last for the duration of said agreement.7.That Article VII-A be completely deleted.8.That Art.IX \u2014 Payment of wages, be completely cancelled and replaced by the following: IX.Payment of wages: The amount of total wage, the number of hours worker, the over-time and the hourly rate must be indicated on salary envelope.9.That Article X.\u2014 Vacation with pay, be completely deleted and replaced by the following: \u2022 X.\u2014 Vacation with pay: Every employee subject to the decree is entitled to vacation with pay pursuant to the following provisions: \" 1) After one year's continuous service in the employ of his employer, to a continuous annual vacation with pay having a minimum duration of seven days; and if he has not yet completed a year's service in the employ of his employer, to a continuous annual vacation with pay having a minimum duration of as many half-days as the number of calendar months during which he has been continuously in the employ of his employer.2) Period of continuous service which gives right to aforesaid vacation: For each annual vacation with pay, the period of continuous service in the employ of an employer which gives right to such vacation, begins on the first day of June of one year and ends on the thirty-first day of May of the following year.3) Continuous service: By \"duration of continuous service\" is meant the period during which the employees is bound by a labour contract to work for his employer, even if the carrying out of the aforesaid contract has been interrupted without the contract being cancelled.Shall not be considered as interrupting the duration of continuous service, days of absence through illness, if the contract has not been cancelled, as also days on which the establishment remains closed, the annual vacation, the term of notice and authorized absences, provided that during such days the employees did not hold any other remunerated employment.Shall not be counted in the period of continuous service, the calendar months during which an employee has not effectively worked even though his labour agreement has not been cancelled. 16 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 4) Rémunération: Le salarié a droit pour son congé, à une rémunération équivalente à deux pour cent (2%) du salaire gagné en incluant l'indemnité pour vacances durant la période s'éten-dant du 1er juin au 31 mai suivant ét lui donnant droit à tel congé, s'il est payé suivant un autre mode.5) Avantages additionnels: Durant le congé de son salarié, l'employeur doit continuer à lui procurer les avantages en nature et autres auxquels il a droit, tels que la contribution à un fonds de pension, la contribution à une police d'assurance-groupe sur la vie, les bénéfices de soins médicaux, etc.6) Échéance de la rémunération: Avant le départ du salarié visé par le paragraphe 4 de l'article X, l'employeur doit lui payer sa rémunération pour congé.7) Période de prise de congé: Chaque congé doit être donné dans les douze mois de la date à laquelle le droit à tel congé est acquis, i.e.au 1er juin de chaque année.8) Fixation de la période de congé: Le salarié a le droit de connaître au moins quinze jours à l'avance la période de son congé.9) Résiliation du contrat de travail: Lors de la résiliation de son contrat de travail, le salarié lui-même a droit à une indemnité représentant deux pour cent (2%) du salaire gagné depuis le premier juin précédant la date de son départ.10) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 9 inclusivement du présent article X, il sera loisible à tout employeur de remplacer par une indemnité compensatrice égale à la rémunération prévue au paragraphe 4 le congé annuel payé prescrit par le présent décret à condition que chaque employé visé en donne son consentement par écrit.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.0 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 8 janvier 1955.3S957-0 4) Remuneration : For his vacation, the employee is entitled to a remuneration equal to two per cent (2%) of the wages earned including vacation indemnity during the period extending from the 1st of June to the 31st of May next entitling him to such vacation, if he is paid on any other basis.5) Additional advantages: During the vacation of his employee, the employer shall continue to procure for him the advantages to which he is entitled, whetheï in kind or of another nature, such as the contribution to a pension fund, the contribution to a group life-insurance policy, sick benefits, etc.0) Date of payment of remuneration: The vacation pay shall be given by the employer to his employee governed by section X, subsection 4, before the said employee's departure on vacation.7) Period during which vacation is to be taken: Every vacation shall be given \u2022 within twelve months from the date on which the right to such vacation is acquired, i.e.the 1st of June of every year.8) Fixing the date of vacation: The employee has the'right to know the date of his vacation at least fifteen days in advance.9) Cancellation of labour contract: At the time of the cancellation of his labour contract, the employee himself is entitled to an indemnity consisting of two percent (2%) of the wages earned after the 1st of June preceding the date of his departure.10) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 to 9 inclusive of the present article X, any employer may replace by a compensating indemnity equal to the remuneration provided in paragraph 4 the annual vacation with pay prescribed by the present decree provided that any employee concerned shall give his consent therefore in writing.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 8th, 1954.38957-0 Ministère des Finances Assurances Loi des Assurances de Québec AVIS Les soussignés, Laurent Labelle, industriel, domicilié au N° 2785 Chemin Ste-Catherine, Montréal; Paul-Emile Ménard, gérant, domicilié au N° 359 boulevard St-Joseph est, Montréal; Henri Gareau, comptable, domicilié au N° 2925, boulevard Graham, ville Mont-Royal; J.-Édouard Jeannottc, notaire, domicilié au N° 3575 rue Sherbrooke est, Montréal; Jean Trudel, avocat, conseil en loi de la Reine, domicilié au N° 3503, rue Addington, Montréal, donne avis qu'ils ont l'intention de s'adresser au Lieutenant-gouverneur en conseil, le priant de les constituer en corporation de compagnie d'assurance, aux fins de transiger les groupes suivants d'assurance et de réassurance: contre les accidents, d'automobiles, d'aviation, contre le vol Department of Finance Insurances Quebec Insurance Act NOTICE The undersigned, Laurent Labelle, industrialist, residing at No.2875 St.Catherine Road, Montreal; Paul Emile Ménard, manager, residing at No.359 St.Joseph Boulevard, east, Montreal; Henri Gareau, accountant, residing at No.2925 Graham Boulevard, town of Mount Royal; J.Edouard Jeannotte, notary, residing at No.3575, Sherbrooke Street, east, Montreal; Jean Trudel, advocate, Queen's Counsel, residing at No.3503, Addington Street, Montreal, give notice that they intend applying to the Lieutenant-Governor in Council, praying him to incorporate them as an insurance company, for the purpose of transacting one of the following groups of insurance and reinsurance: accident, automobile, aviation, larceny, housebreaking QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol.87, No.1 17 avec ou sans effraction, de crédit, contre les explosions, contre le feu, contre le faux, de garantie, contre la grêle, industrielle, responsabilité publique, de navigation intérieure, des transports intérieurs, sur le bétail, maritime océanique, contre le bris de glace, contre la maladie, contre les défectuosités dans les arrosoirs automatiques, sur les chaudières à vapeur, contre les cyclones, contre l'intempérie, ou tout autre groupe d'assurance ou de réassurance, excepté l'assurance-vie, avec siège social en la cité de Montréal, au capital-actions de $500,-000.00 divisé en 5,000 actions de $100 chacune, le tout en conformité de la loi des assurances de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 299).Le nom de la compagnie sera: \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal\".Montréal, 20 décembre 1954.LAURENT LABELLE, PAUL-ÊMILE MÉNARD, HENRI GAREAU, J.-ÉDOUARD JEANNOTTE, 38919-53-4-0 JEAN TRUDEL.Nomination Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commission, de faire la nomination suivante: Québec, le 3 novembre 1954.Docteur Arthur Simard, médecin à Sainte-Anne-de-Beaupré: coroner conjoint du district judiciaire de Québec, avec juridiction sur le district électoral de Montmorency.38936-0 Sièges sociaux AVIS PUBLIC \u2022 Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Grandmont Construction Inc.,\" constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes accordées en vertu de la Loi des compagnies de Québec, le 10 mai 1951, et ayant son siège social à Granby où son bureau d'affaires était situé à 233, rue Principale, aura, à compter du 2 janvier 1955, son bureau d'affaires à 245, rue St-Charles Sud, Granby.A compter de cette date, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant le siège social de la compagnie.Daté à Montréal, ce 30 décembre 1954.Le Président de la compagnie, 38947-0 GASTON POULIOT, avocat.(P.G.11427-54) Air Chefs Inc.Règlement \"A\" Un règlement pour changer la situation du siège social de la compagnie.Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété que le siège social de la compagnie soit trans- or burglary, credit, explosion, fire, forgery, quarantec, hail, industrial, public liability, inland marine, inland transportation, livestock, ocean marine, plate glass, sickness, spinkler leakage, steam boiler, tornado, weather, or any other class of insurance or reinsurance, save and except life insurance, with head office in the city of Montreal, with a share capital in the amount of $500,000.00 divided into 5,000 shares of $100 each, all of which pursuant to the Quebec Insurance Act (R.S.Q.1941, chapter 299).The name of the company shall be: \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal\".Montreal, December 20th, 1954.LAURENT LABELLE, PAUL EMILE MÉNARD, HENRI GAREAU, J.EDOUARD JEANNOTTE, 38919-53-4 JEAN TRUDEL.Appointment His Honour the Lieutenant-Governor, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, has been pleased to make the following appointment: Quebec, November 3rd, 1954.Doctor Arthur Simard, physician at Sainte-Anne-de-Beaupré: Joint Coroner of the judicial district of Quebec, with jurisdiction over the electoral district of Montmorency.38930 Head Offices PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the company \"Grandmont Construction Inc.,\" incorporated in the Province of Quebec by letters patent issued under the Quebec Companies' Act, on May 16th, 1951, and having its head office at Granby where its business office was situate at 233, Principal Street, will have its business office at 245, St-Charles Street south, Granby, from and after January 2nd, 1955.From and after this date, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 30th day of December, 1954.GASTON POULIOT, Advocate, 38947 President of the company.(A.G.11427-54) Air Chefs Inc.By-law \"A\" A by-law to change the Head Office of the company.Be it and it is hereby enacted that the place at which the head office of the company shall 18 H GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 porté de la cité de Montréal, province de Québec, à la ville de Dorval, province de Québec.É« Je.lcV soussigné, secrétaire de \"Air Chefs Inc.\", certifie, par les présentes, que le précédent est line vraie copie du règlement \"A\" des règlements de \"Air Chefs Inc.\" dûment décrété par les-directeurs de la compagnie le 1er jour de septembre 1954, et sanctionné et confirmé à l'unanimité par les actionnaires de la compagnie à une assemblée générale spéciale des action-naircs dûment convoquée et tenue à cette fin le même jour.Témoins: Ma signature et le sceau de la compagnie apposé à Montréal le 19e jour de novembre 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 38950 CLAUDE BAILLARGEON.be situate be changed from the city of Montreal, in the Province of Quebec, to the town of Dorval, in the Province of Quebec.I, \"the undersigned, Secretary of \"Air Chefs Inc.\", hereby certify that the foregoing is a true copy of By-law \"A\" of the By-laws of \"Air Chefs Inc.\", duly enacted by the Directors of the company on the 1st day of September, 1954 and unanimously sanctioned and confirmed by the shareholders of the company at a special general meeting of shareholders duly called and held for the purpose on the same day.Witness my hand and the seal fo the company at Montreal, on this 19th day of November, 1954.(Seal) CLAUDE BAILLARGEON, 3S950-o Secretarv.Soumissions Tenders Province de Québec Les com.miss ai hks d'écoles pour la municipalité de mont-ïbemblant (Comté de Terrebonne) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Rosaire Dubois, secrétaire-trésorier, C.P.0, Mont-Tremblant village, comté de Terrebonne, jusqu'à 7 heures p.m.lundi, le 24 janvier 1955, pour l'achat de S50.000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de Mont-Tremblant, comté de Terrebonne, datées du 1er février 1955 et remboursables par séries du 1er février 1950 au 1er février 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4J^% par année payable semi-annuel-Iement les 1er août et 1er février de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 15 octobre 1954, telle que modifiée \u2014 Construction d'une école élémentaire au village et dépenses incidentes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er février 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $50,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er février 1950 .xS10,000.00 1er février 1957 .x 17,000.00 1er février 1958 .500.00 1er février 1959 .500.00 1er février 1900 .500.00 1er février 1901 .500.00 1er février 1902 .1,000.00 1er février 1903 .1,000.00 1er février 1904.1,000.00 1er février 1905 .1,000.00 1er février 1900 .1,000.00 1er février 1907 .1,000.00 1er février 1908 .1,000.00 1er février 1909 .1,000.00 1er février 1970 .1,000.00 1er février 1971 .1,000.00 1er février 1972 .1,000.00 1er février 1973 .1,000.00 1er février 1974 .1,500.00 1er février 1975 .1,500.00 Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of Moxt-Tremhl.wt (County of Terrebonne) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Rosaire Dubois, Secretary-Tr.easurer, P.O.Box G, Mont-Tremblant Village, county of Terrebonne, until 7 o'clock p.m., Monday, January 24th, 1955, for the purchase of an issue of §50,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of Mont-Tremblant, county of Terrebonne, dated February 1st, 1955 and redeemable serially from February 1st, 1950 to February 1st, 1975 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4j/£% per annum, payable semi-annually on August 1st and February 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated October 15th.1954, as amended \u2014 Construction of an elementary school in the village and incidental expenditures.Only for the purposes of awarding the issue, computation of interest will be made as from February 1st, 1955.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 850,000.00 \u2014 $0 years Year Capital February 1st, 1950 .xS 10,000.00 February 1st, 1957 .x 17,000.00 February 1st, 1958 .500.00 February 1st, 1959 .500.00 February 1st, 1900 .500.00 February 1st, 1901 .500.00 February 1st, 1902 .1,000.00 February 1st, 1903 .1,000.00 February 1st, 1904 .1,000.00 February 1st, 1905 .1,000.00 February 1st, 1900 .1,000.00 February 1st, 1907 .1,000.00 February 1st, 1908 .1,000.00 February 1st, 1909 .1,000.00 February 1st, 1970 .1,000.00 February 1st, 1971 .1,000.00 February 1 st, 1972 .1,000.00 February 1st, 1973 .1,000.00 February 1st, 1974 .1,500.00 February 1st, 1975 .1,500.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 8th, 1955, Vol 87, No.1 10 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 834,125.00, accordé par le Secrétaire de la Province et payable en deux versements de S 17,002.-50 chacun, en 1950 et en 1957, seront reçus et appliqués au.service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Mont-Tremblant, comté de Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables au bureau principal d'une banque à charte à Montréal, Québec, St-.Iovitc ou Mont-Tremblant, comté de Terrebonne.Lcsdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 24 janvier 1955, à 7 heures p.m., en la salle du collège, Mont-Tremblant, comté de Terrebonne.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mont-Tremblant, (Comté de Terrebonne), ce 4 janvier 1955.Le Secrétaire-trésorier, ROSAIRE DUBOIS.CP.0, Mont-Tremblant, (Comté de Terrebonne), P.Q.38952-0 The \"x\" indicate the years during which annua payments of a total amount of $34,125.00, granted by the Provincial Secretary and payable in two instalments of $17,062.50 each, in 1956 and in 1957, will be received and applied to the service of this loan.The successful tenderer agrees to .pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Mont-Trcm-blant, county of Tcrretonen.Capital and interest are payable at the principal office of a chartered bank in .Montreal, Quebec, St.Jovite ou Mont-Tremblant, county of Terrebonne.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered ,-it a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, January 24th, 1955 at 7 o'clock p.m., in the college hall.Mont-Tremblant.county of Terrebonne.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Mont-Tremblant, (County of Terrebonne), this 4th of January, 1955.ROSAIRE DUBOIS, Secretary-Treasurer.P.O.Box 0, Mont-Tremblant, (County of Terrebonne), P.Q.38952-0 VENTES PAR SHÊRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le présent donné que PUBLIC NOTICE is hereby given that the les TERRES ET HERITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Cour Supérieure, (T\\R ROBERT LAMBERT, N° 5805 < U demandeur, vs BER-INARD CHÔINIÈRE, défendeur.Comme appartenant au défendeur.\"Un terrain de forme rectangulaire sis et situé sur le côté nord-ouest de la rue Court, en la cité de Granby, mesurant soixante pieds de largeur par cent trente pieds de profondeur connu et désigné comme étant le lot numéro cent vingt-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro sept cent seize (710-124) aux plan et livre de renvoi officiel du cadastre pour le canton maintenant cité de Granby, avec bâtisses dessus, le tout mesure anglaise.Le dit terrain borné au nord-est par le lot N° 710-123 au nord-ouest par le lot 017-90 au sud est par la rue Court, et au sud-ouest par le lot 716-125.\" Pour être vendu à la porte de l'église catholique de St-Joseph de Granby, (lit district, BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Quebec Superior Court, I TNR ROBERT LAMBERT, No.5805 { U plaintiff, vs BERNARD l CHÔINIÈRE, defendant.As belonging to the defendant.\"A parcel of land of irregular form located and situate on the northwest side of Court Street, in the city of Granby, measuring sixty feet in width by one hundred and thirty feet in depth known and designated as being lot number one hundred and twenty-four of the official subdivision of the original lot number seven hundred and sixteen (716-J 24) on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the township now city of Granby, with buildings thereon, the whole English measure.The said parcel of land bounded on the north-cast by lot No.716-123 on the northwest by lot 617-90 on the southeast by Court Street, and on the southwest by lot 710-125.\" To be sold at the door of the Catholic church of St-Joseph of Granby, said district, WED- 20 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 janvier 1955, Tome 87, N° 1 MERCREDI le NEUF FÉVRIER 1955, DIX heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, \" A.ST.MARTIN.Palais de Justice, Sweetsburg, Québec.à NESDAY, on FEBRUARY NINTH, 1955 at TEN o'clock in the forenoon.A.ST.MARTIN, Sheriffs Office, Sheriff.Court House, 38954-1-2-0 Sweetsburg, Quebec.38954-1-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District, de Kamouraska Cour Supérieure, ( T-J O R A CE D U M O N T, N° 19094.< *¦ plombier de la cité de v Rivière-du-Loup, demandeur; vs JOSÉPHINE MORIN, de Notre-Dame du Portage, défenderesse.\"Un terrain contenant un arpent et demi de front est-ouest sur environ deux arpents de profondeur tel (pie compris dans les bornes suivantes: Au nord au chemin public, au sud au sommet de la première côte qu'il y a au sud du chemin, à l'est à Henri Lebel et à l'ouest à Charles Eugène Raymond, avec la maison servant d'auberge ou restaurant y érigé, autres dépendances et circonstances, lequel terrain fait partie du lot numéro trente-six (Pt 30) du cadastre officiel de Notre-Dame du Portage, dans le comté de Kamouraska.\" Pour être vendu à la porte de l'église de Notre-Dame du Portage, MERCREDI, le NEUVIÈME jour de FÉVRIER à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, 4 janvier, 1955.38902-1-2-o [Première insertion, samedi le 8 janvier, 1955].KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Superior Court, t T-JORACE DUMONT, plum-No.19094.< A J- ber of the city of Rivière-l du-Loup, plaintiff; vs JOSÉPHINE MORIN, of Notre-Dame du Portage, defendant.\"A piece of land containing one arpent and a half in frontage east-westerly, by some two arpents in depth such as included in the following boundaries: northerly, by the public highway, southerly by the top of the first hill situated south of the road, easterly by Henri Lebcl and westerly by Charles Eugène Raymond, with house erected thereon serving as an inn or restaurant, with other dependencies and circumstances, which land forms part of lot number thirty-six (Pt 30) of the official cadastre of Notre-Dame du Portage, in the county of Kamouraska.\" To be sold at the Church door of Notre-Dame du Portage, WEDNESDAY, the NINTH day of FEBRUARY at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière du Loup, January 4th, 1955.38902-1 -2 [First insertion, Saturday, January 8th, 1955].Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Cour de Magistrat, ( \"D OMÉO SAVARD, mar- Magistrate's Court, ( ~D OMÉO SAVARD, mer-N° 18846 < chaud de la cité de No.18840 < ^ chant of the city of \\ Rivière - du - Loup, deman- (.Rivière du Loup, plaintiff, Rivière - du - Loup, demandeur; vs ALPHONSE SIROIS, de St-Athanase, défendeur.\"Le lot numéro quarante (40) rang huit (8), canton Chabot, dans la paroisse de St-Athanase.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église de St-Athanase, MARDI le HUITIÈME jour de FÉVRIER 1955, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, 28 décembre 1954.38955-l-2-o [Première insertion, samedi le 8 janvier 1955] MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal à savoir: / t \"«OFFICE DU CRÉDIT N° 358782.< ^ AGRICOLE DU (QUÉBEC, requérant; vs ALDÉO PRIMEAU, intimé.Une terre contenant environ cent quarante arpents en superficie avec maison et autres bâtisses y érigées, connue et désignée comme étant les lots numéros deux cent onze et deux cent douze (211-212) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jacques le Mineur, comté de Laprairie: à distraire du lot N° 212, vs ALPHONSE SIROIS, of St.Athanase, de-fendant.\"Lot number forty (40) range eight (8), township of Chabot, in the parish of St.Athanase.All of which with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the church door of St.Athanase, TUESDAY, the EIGHTH day of FEBRUARY 1955 at TWO o'clock in the afternoon.P.E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière du Loup, December 28th, 1954.38955-1-2 [First insertion, Saturday, January 8th, 1955] MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: ( /QUEBEC FARM CRE-No.358782.< v
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.