Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 mars 1955, samedi 19 (no 11)
[" Tome 87, N° 11 945 Vol.87, No.11 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Officiai Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 19 mars 1955 Quebec, Saturday, March 19th, 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS NOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements Rules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The Queen's meur de la Reine, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine will be suspended without further notice and qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute without prejudice as regards the rights of the somme versée en plus.Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank mandat de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada as second class mailable matter. 946 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause tie leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933\u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.10105-55) Aetna Factors Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier jour de février 1955, constituant en corporation: David Lack, Baruch Pollack, avocats, Pearl Auerbach, Sylvia Teitlebaum, secrétaires, célibataires et Harry Closner, gérant de crédit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme courtiers d'assurances générales et agents financiers, sous le nom de \"Aetna Factors Corporation Ltd.\" avec un capital total|de $500,000, divisé en 15,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district, judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, foi each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the tljird the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.38933 \u2014 1-52 s Letters Patent (A.G.10105-55) Aetna Factors Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of February, 1955, incorporating: David Lack, Baruch Pollack, advocates.Pearl Auerbach, Sylvia Teitlebaum, secretaries, unmarried, and Harry Closner, credit manager, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business as general insurance brokers and financial'agents, under the name of \"Aetna Factors Corporation Ltd.\", with a total capital stock of $500,000, divided into 15,000 common shares of a par value of $10 each and into 3,500 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol 87, No.11 947 (P.G.10230-55) Aubert Construction Lice Avis est donné qu'on vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un janvier 1955, constituant en corporation: Lovell C.CarrolL CH., Jacqucs-P.Dansereau, tous deux avocats, de Montréal, et John Bumbray, C.R., avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Aubert Construction Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10335-55) Bellevue Service Station Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Sylva St-Maurice, garagiste, Sheila St-Maurice, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Sylva St-Maurice, et Mary H.Whitehead, ménagère, tous d'Arvida, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de garagiste, sous le nom de \"Bellevue Service Station Limitée\", avec un capital total de $75,000, divisé en 750 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 370, rue St-Hubert, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général^ le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10387-55) Bouchard & Frères Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mars 1955, constituant en corporation: Gilles Bouchard, André Bouchard et Irénée Bouchard, tous marchands des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de bois, huile, charbon et glace; exercer l'industrie de transport général de marchandises par camions-automobiles, sous le nom de \"Bouchard & Frères Inc.\", avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et en 7,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social» de la compagnie sera à 2097, rue Balbwin, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(A.G.10230-55) Aubert Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1955, incorporating: Lovell C.Carroll, Q.C., Jacques-P.Dansereau, both advocates of Montreal, and John Bumbray, Q.C., advocate of the town of Mount-Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a construction company, under the name of \"Aubert Construction Ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 20,000 common shares of SI each and into 4,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10335-55) Bellevue Service Station Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Sylva St-Maurice, garage-keeper, Sheila St-Maurice housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Sylva St-Maurice, and Mary II.Whitehead, housekeeper, all of Arvida, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on a business as garage-keeper, under the name of \"Bellevue Service Station Limitée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 common shares of S100 each.The head office of the company will be at 370 St-Hubert Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10387-55) Bouchard & Frères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of March, 1955, incorporating: Gilles Bouchard, André Bouchard and Irénée Bouchard, all merchants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal in wood, oil, coal and ice; to operate, by means of motor trucks, a general transportation business dealing in merchandise, under the name of \"Bouchard & Frères Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without nominal or par value and into 7,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 2097 Baldwin Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of March, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General. 948 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tom.e 87, N° 11 (P.G.10345-55) Brcssani Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit février 1955, constituant en corporation: Max Slapack, Gregory Charlap, avocats, Harry Closner, gérant de crédit, Ray Caplin et Sylvia Teitlebaum, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recheches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Bressani Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de §5,000,000, divisé' en 5iOOO,000 d'actions d'une valeur au pair de SI chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10374-55) Costanzo & Charest Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze février 1955, constituant en corporation: François Costanzo, industriel, Roger Charest, marchand, et André Trottier, comptable agréé, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire affaires comme bijoutier, sous le nom de \"Costanzo & Charest Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de S40 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le onze février 1955.L'Assistant-procu reu r général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10191-55) Domain Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de.Québec, des lettres patentes en date du trente et unième jour de janvier 1955, constituant en corporation: Hyman Rosenfeld, notaire, Eli Michael Berger et Irving Halperin, avocats, tous des cité et district-judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs et constructeurs généraux, sous le nom de \"Domain Development Corp.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 2,500 actions privilégiées de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce trente et unième jour de janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(A.G.10345-55) Bressani Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1955, incorporating: Max Slapack, Gregory Charlap, advocates, Harry Closner, credit manager, Ray Caplin and Sylvia Teitlebaum, secretaries, spinsters of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Bressani Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility' in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-0 Deputy Attorney General.(A.G\".10374-55) Costanzo & Charest Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February, 1955, incorporating: François Costanzo, industrialist, Roger Charest, merchant, and André Trottier, chartered accountant, all of Sherbrooke, judicial district, of Saint-Francis, for the following purposes: To carry on business as a jeweller, under the name of \"Costanzo & Charest Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 shares of a par value of $40 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10191-55) Domain Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1955, incorporating: Hyman Rosenfeld, notary, Eli Michael Berger and Irving Halperin, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business as general contractors and builders, under the name of \"Domain Development Corp.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 250 common shares of a par value of $100 each and into 2,500 preferred shares of $20 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtv-first day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39437-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 949 (P.G.10241-55) Eastern Beef Packers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept janvier 1955, constituant en corporation: Hyman Roscnfeld, notaire, Eli Michael Berger et Irving Halperin, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de denrées alimentaires en général et de produits animaux, laitiers, agricoles et maraîchers de toutes sortes, sous le nom de \"Eastern Beef Packers Ltd.\", avec un capital total de §75,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune et 2,500 actions privilégiées de $20.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10237-55) Ellen-Dec Fashions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier jour de.février 1955, constituant en corporation: Max Coblentz, Moses Feigenbaum, avocats, de Montréal et Gladys Watson, secrétaire, veuve du défunt Everett Watson, de son vivant fabricant de matrices, de Verdun, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements, articles vestimentaires et tissus, sous le nom de \"Ellen-Dee Fashions Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce premier jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10352-55) Emdeco Limitée \u2014 Emdcco Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1955, constituant en corporation: Maurice Gagné, c.r., Jacques Flynn, c.r., tous deux avocats, de Québec, et Julien Choui-nard, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, 'métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et les sous-produits d'iceux, des merceries, produits comestibles, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et périodiques, peintures, travaux d'art, produits chimiques, produits de la terre, de la mer et des forêts, produits de beauté, articles de toilette et parfums, sous le nom de \"Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.(A.G.10241-55) Eastern Beef Packers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January, 1955, incorporating: Hyman Rosenfeld, notary, Eli Michael Berger and Irving Ilalperin, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in food produce generally, animal, dairy, farm and garden produce of all kinds, under the name of \"Eastern Beef Packers Ltd.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and into 2,500 preferred shares of $20.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10237-55) Ellen-Dee Fashions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of February, 1955, incorporating: Max Cob-lentz, Moses Feigenbaum, advocates, of Montreal, and Gladys Watson, secretary, widow of the late Everett Watson, in his lifetime die maker of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing, wearing apparel and fabrics, under the name of \"Ellen-Dee Fashions Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10352-55) Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1955, incorporating: Maurice Gagné, Q.C., Jacques Flynn, Q.C., both advocates of Quebec, and Julien Chouinard, advocate of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes.To carry on the business of and deal in products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, metalloid, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products thereof, drygoods, food products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, book oand periodicals, paintings, works of art, chemical products, products of the earth, sea and forests, beauty products, toilet articles and perfumes, under the name of \"Emdeco Limitée\u2014 Emdeco Limited, with a total capital stock of S10,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each. 950 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 Le siège social de la compagnies sera à Québec, district judiciaires de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le neuf février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10364-55) Guarantee Commercial Exchange Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuvième jour tic février 1955, constituant en corporation: Marcus M.Sperber, Cit., avocat, de West mount, Alan B.Gold, avocat, de Montréal et Murray Lapin, avocat, de Hamps-tead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités le commerce de courtiers d'assurances, sous le nom de \"Guarantee Commercial Exchange Inc.\", avec un capital total de 825,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 407 rue McGill, suite 610 Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10260-55) IL Wcxlcr Sons & Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq février 1955, constituant en corporation: Bernard Wexler, Saul Wexler, tous deux marchands, et Alex Migicovsky, vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandises sèches, fourrures, chapeaux et casquettes, vêtements, garnitures de tailleurs et tissus textiles de toutes sortes, sous le nom de \"H.Wexler Sons & Company\", avec un capital total de 8150,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de 810 chacune et 10,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10277-55) Imperial Tire Sales Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été .accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deuxième jour de février 1955, constituant en corporation: John Austin Murphy, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Pierre Décary, «avocat.Francis Joseph Dolan, comptable et Mildred Murphy, ménagère, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers et marchands de pneus d'automobiles, chambre à air, accessoires et toutes sortes de march an- The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10364-55) Guarantee Commercial Exchange Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1955, incorporating: Marcus M.Sperber, Q.C, advocate, of Westmount, Alan B.Gold, advocate, of Montreal, and Murray Lapin, advocate, of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of insurance brokers, under the name of \"Guarantee Commercial Exchange Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,000 common shares of the par value of S10 each and into 1,500 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at 407 McGill Street, Suite 610, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39137-0 Deputy Attorney General.(A.G.10260-55) H.Wexler Sons & Company- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of February, 1955, incorporating: Bernard Wexler, Saul Wexler, both merchants, and Alex Migicovsky, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, furs, hats and caps, clothing, tailors' trimmings and textile fabrics of all kinds, under the name of \"H.Wexler Sons & Company\", with a total capital stock of 8150,000, divided into 5,000 common shares of 810 each and into 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-0 Deputy Attorney General.(A.G.10277-55) Imperial Tire Sales Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-GovernoK of the Province of Quebec, bearing date the second day of February, 1955, incorporating: John Austin Murphy, advocate and Queen's Counsel, Pierre Décary, advocate, Francis Joseph Dolan, accountant, and Mildred Murphy, housekeeper, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in automobile tires, tubes and accessories and all descriptions of rubber goods, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 951 discs en caoutchouc, sous le nom de \"Imperial Tire Sales Limited\", avec un capital total de $75,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et 000 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.O.10347-55) Jean Bourbonnière Hardware Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1955, constituant en corporation: Paid Trudeau, de ville Mont-Royal, Adolphe Prévost et Mario Laurier, de Montréal, tous avocats, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quincaillerie, d'accessoires électriques et d'équipments de toutes sortes, sous le nom de \"Jean Bourbonnière Hardware Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 807, rue Ontario, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10337-55) J.L.Gingras Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf février 1955, constituant en corporation: Roger-Louis Beaulicu, avocat, de Westmount, Jérôme Choquctte, avocat, de Montréal, et William Tetley, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de transport de personnes, effets, denrées et marchandises, sous le nom de \"J.L.Gingras Limitée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 800 actions de 825 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-Q C.E.CANTIN.(P.G.10302-55) Ken Story Garage Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sept février 1955, constituant en corporation: John Foster Chisholm, avocat et.conseil en loi de la Reine, Richard Dale Wcldon et John William Durnford, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Gérer et exploiter des garages, sous le nom de \"Ken Story Garage Ltd.\", avec un capital total under the name of \"Imperial Tire Sales Limited\", with a total capital stock of $75,000, divided into 1,500 common shares of 810 each and into 000 preferred shares of §100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of-Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10347-55) Jean Bourbonnière Hardware Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1955, incorporating: Paul Trudeau, of the town of Mount-Royal, Adolphe Prévost, and Mario Laurier, of Montreal, all advocates, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a business-dealing in hardware, electrical accessories and equipment of all kind, under the name of \"Jean Bourbonnière Hardware Limited\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 250 common shares of 8100 each and into 150 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 807 Ontario Street, East, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10337-55) J.L.Gingras Limitée Notice is hereby given that under Part I of .the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of February, 1955, incorporating: Roger-Louis Beaulieu, advocate, of Westmount, Jérôme Choquctte, advocate, of Montreal, and William Tetley, advocate, of the town of Mount-Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a carrying company, covering persons, effects, foodstuffs and merchandise, under the name of \"J.L.Gingras Limitée\", with a total capital stock of 820,000, divided into 800 shares of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10302-55) Ken Story Garage Ltd.* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of February, 1955, incorporating: John Foster Chisholm,' advocate and Queen's Counsel, Richard Dale Weldon and John William Durnford, advocates, all of the city and, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manage and operate garages, under the name of \"Ken Story Garage Ltd.'', with a total. 952 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 de $40,000, divisé en 1,600 actions de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept février 1955.L*Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10209-55) Lake Bcauport Industries Ltd Les Industries Lac Bcauport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois février 1955, constituant en corporation: Cyril B.Bignell, courtier en assurance, Léo C.Monaghan, employé civil, tous deux de Lac Bcauport, et J.Derek Martin, courtier en assurance, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Lake Bcauport Industries Ltd \u2014Les Industries Lac Bcauport Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 100 actions privilégiés de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trois février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.capital stock of $40,000, divided into 1,600 shares of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10209-55) Lake Beauport Industries Ltd Les Industries Lac Beauport Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of February, 1955, incorporating: Cyril B.Bignell, insurance broker, Léo C.Monaghan, civil employee, both of Lake Beauport, and J.Derek Martin, insurance broker, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Lake Beauport Industries Ltd \u2014 Les Industries Lac Beauport Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this third day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(P.G.10274-55) Les Constructions de la Haute Ville de Châteauguay Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la.Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze février 1955, constituant en corporation: Gérard Bourdon, cultivateur, Berthe Desparois-Bourdon, ménagère, épouse commune en biens dudit Gérard Bourdon, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Léo Desparois, entrepreneur, et Géraldine Chassé-Despa-rois, ménagère, épouse séparée de biens dudit Léo Desparois, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Châteauguay, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Les Constructions de la Haute Ville de Châteauguay Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Châteauguay, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le douze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10369-55) Les Immeubles Du Mont Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix février 1955, constituant en corporation: Jean-Marie Nadcàu, étudiant, Lucette Nadeau Cadrin, ménagère, épouse séparée de biens de Jean-Paul Cadrin, et dûment, autorisée par lui (A.G.10274-55) Les Constructions de la Haute Ville de Châteauguay Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent1 have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February, 1955, incorporating: Gérard Bourdon, farmer, Berthe Desparois-Bourdon, housekeeper, wife common as to property of the said Gérard Bourdon, and duly authorized by him for these present purposes, Léo Desparois, contractor, and Géraldine Chassé-Desparois, housekeeper, wife separate as to property of the said Léo Desparois, and duly authorized by him for these present purposes, all of Châteauguay, judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Les Constructions de la Haute Ville de Châteauguay Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Châteauguay, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10369-55) Les Immeubles Du Mont Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of February, 1955, incorporating: Jean-Marie Nadeau, student, Lucette Nadeau Cadrin, housekeeper, wife separate as to property of Jean-Paul Cadrin, and duly authorized by him for QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 953 aux fins des présentes, et Jean-Paul Cadrin, notaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Du Mont Ltée\", avec un capital total de 820,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-Q C.E.CANTIN.(P.G.10270-55) Maison Alysc Inc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour de février 1955, constituant en corporation: Julius Léonard Stobcr, ingénieur, Caroline Rothman Stober, ménagère, épouse séparée de biens dudit Julius Léonard Stober et dûment autorisé par lui aux fins des présentes, Rachel Schnarr Knopp,.ménagère, épouse séparée de biens de Harry Knopp, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de vêtements prêts à porter pour dames et faire le commerce général .d'articles vestimentaires, articles de mode, coiffures et vêtements, soie, broderies, dentelles nouveautés, fourrure, marchandises sèches, garnitures pour tailleur et en général marchandises similaires, sous le nom de \"Maison Alyse Inc\", avec un capital total de $10,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10314-55) Northland Lithium Mines Ltd (Libre de Responsabilité Personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: J.-Éloi Gervais, Damase Brissettc, avocats, de Longueuil, et Jacqueline Laliberté, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier sous le nom de \"Northland Lithium Mines Ltd\" (Libre de Responsabilité Personnelle), avec un capital total de $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C, E.CANTIN.these present purposes, and Jean-Paul Cadrin, notary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of and deal in immoveables, under the name of \"Les Immeubles Du Mont Ltée\", with a total capital stock of S20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10270-55) Maison Alysc Inc Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: Julius Léonard Stober, engineer, Caroline Rothman Stober, housewife, wife separate as to property of the said Julius Léonard Stober, and duly authorized by him for the purpose of these presents, Rachel Schnarr Knopp, housewife, wife separate as to property of Harry Knopp, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general ladies' ready-to-wear business and deal in general wearing .apparel, millinery, headwear and wearing apparel, silk, embroidery, lace, novelties, fur, dry goods, tailors' trimmings, and similar merchandise generally, under the name of \"Maison Alyse Inc\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of a par value of $100 each and into 250 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-Q Deputy Attorney General.(A.G.10314-55) Northland Lithium Mines Ltd (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: J.-ÉIoi Gervais, Damase Brissette, advocates, of Longueuil, and Jacqueline Laliberté, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Northland Lithium Mines Ltd\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,000 divided into 5,000,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at thé office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General. 954 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 (P.G.10499-55) Peppe's Restaurant (Quebec) lue.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, dés lettres patentes en date du vingt-quatre février 1955, constituant en corporation: Pcppc De Vincenzo, Angelo De Vincenzo, tous deux restaurateurs, de Montréal et Mario E.Lattoni, Cit., procureur, de West-mount,] tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"Peppe's Restaurant (Quebec) Inc.\", avec un capital total de §35,000, divisé en 350 actions de S100 chacune.Le siège social de la companie sera à 203 rue St-Jcan, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39137 C.E.CANTIN.(P.G.10208-55) Pin/a Realty Inc.Avis est donné (pi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois février 1955, constituant en corporation: George Sheincr, administrateur, de Ville Mont-Royal, Morty Deckelbaum, administrateur, de Montréal et Max S.Kaufman, avocat, de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Négocier des immeubles, sous le nom de \"Plaza Realty Inc.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 500 actions ordinaires de §10 chacune et 350 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10377-55) Radio City Music Hall Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de là Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze février 1955, constituant en corporation: Jean-Pierre Desmarais, industriel, Roger Beau-lieu, avocat, et Lorraine Lavigne, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter ou gérer des théâtres, des cinémas, des salles de concerts ou de conférences, des studios pour émissions radiophoniques ou télévisées, sous le nom de \"Radio City Music Hall Inc.\", avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale et en 1,900 actions privilégiées de §50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E, CANTJN, (A.G.10499-55) Peppe's Restaurant (Quebec) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1955, incorporating: Peppe De Yincenzo, Angelo De Vincenzo, both restaurateurs, of Montreal, and Mario E.Lattoni, Q.C, barrister, of Wcstmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Peppe's Restaurant (Quebec) Inc.\", with a total capita] stock of §35.000, divided into 350 shares of §100 each.The head office of the company will be at 203, St.John Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10208-55) Plaza Really Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of February, 1955, incorporating: George Sheiner, executive, of the town of Mount Royal, Morty Deckelbaum, executive, of Montreal, and Max S.Kaufman, advocate, of Wcstmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Plaza Realty Inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 500 common shares of §10 each and into 350 preferred shares of §100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10377-55) Radio City Music Hall Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February, 1955, incorporating: Jean-Pierre Desmarais, industrialist, Roger Beaulieu, advocate, and Lorraine Lavigne, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate or manage theatres, cinemas, concert or lecture halls, radio or television broadcasting studios, under the name of \"Radio City Music Hall Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without nominal or no par value, and in 1,900 preferred shares of §50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 955 (P.G.10240-55) Salaison Lafontainc Packing Inc.Avis est donné que'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept janvier 1955, constituant en corporation: Hyman Rosenfeld, notaire, Êli Michael Berger et Irving Halperin, avocats, tous des cité et district de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tous produits alimentaires, animaux, laitiers, agricoles et maraîchers d'aucune sorte, sous le nom de \"Salaison Lafon-taine Packing Inc.'\", avec un capital total de §40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de §10 chacune et 1,500 actions privilégiées de §20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10303-55) Shcfford Copper Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix février 1955, constituant en corporation: Henri Crépeau, avocat et conseil en loi de la Reine, Henri René Émond, négociant de valeurs mobilières, tous deux de Montréal et Gaston Miquelon, industriel, d'Outrcmont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"ShefFord Copper Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de §4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions ordinaires de §1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du n ontant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à 360 ouest, rue Craig, chambre 316, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10171-55) St.Johns Ready-Mix Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre février 1955, constituant en corporation: Philodor Ouimet, Réal Ouimet et Jean-Guy Ouimet, tous industriels, de Saint-Jean l'Êvangéliste, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: La confection et la livraison de béton {et de ciment préparé, sous le nom de \"St.Johns Ready-Mix Co.Ltd.\", avec un capital total de §59,900, divisé en 599 actions ordinaires de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.(A.G.10240-55) Salaison Lafontainc Packing Inc.Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of January, 1955, incorporating: Hyman Rosenfeld, notary, Eli Michael Berger and Irving Halperin, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in all food and animal products and dairy, farm and garden produce of all kinds, under the name of \"Salaison Lafontainc Packing Inc.\", with a total capital stock of §40.000, divided into 1,000 common shares of §10 each and into 1,500 preferred shares of §20 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of Januarv, 1955.C.E.CANTIN.39437-0 Deputy Attorney General.(A.G.10303-55) Shefford Copper Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of February, 1955, Incorporating: Henri Crépeau, advocate and Queen's Counsel, Henri René Émond, investment dealer, both of Montreal, and Gaston Miquelon, industrialist, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Shefford Copper Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $4,000,-000, divided into 4,000,000 common shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 360 Craig St.West, Room 316, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of February, 1955.C.E.CANTIN/ 39437-0 Deputy Attorney General.(A.G.10171-55) St.Johns Ready-Mix Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: Philodor Ouimet, Real Ouimet and Jean-Guy Ouimet, all industrialists, of Saint-Jean l'Êvangéliste.judicial district of Iberville, for the following purposes: To make and deliver concrete and prepared cement, under the name of^'St.Johns Ready-Mix Co.Ltd.\", with a total capital stock of $59,900, divided into 599 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-John's, judicial district of Ihcrville. 956 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général.39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10342-55) Thctford Transport Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept février 1955, constituant en corporation: Marcel Picbette, comptable, Jean-Louis Brown, commis, et Yves Roy, notaire, tous de Lévis, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exploiter un service de transport en général, sous le nom de \"Thctford Transport Limitée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Thet-ford-Mines, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10236-55) Wilks & Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gpuvemeur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente et un janvier 1955, constituant en corporation: Alexander McTavish Stalker, de Ville Mont-Royal, John Malcolm McDougall, de Montréal et Ian Caldwell Stalker, de Westmount, tous avocats, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme courtiers et agents d'assurances, sous le nom de \"Wilks & Company Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un janvier 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C.E.CANTIN.(P.G.10344-55) Wolfus & Adclstein Fur Mfg.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit février 1955, constituant en corporation: Solomon Wolfus, Isak Adelstein, tous deux manufacturiers et John L.Liberman, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de fourrures et accessoires, sous le nom de \"Wolfus & Adelstein Fur Mfg.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437 C, E, CANTIN, Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10342-55) Thetford Transport Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of February, 1955, incorporating: Marcel Pichette, accountant, Jean-Louis Brown, clerk, and Yves Roy, notary, all of Levis, judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate a general carrying service, under the name of \"Thetford Transport Limitée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Thetford-mines, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10236-55) Wilks & Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province o£ Quebec, bearing date the thirty-first day of January, 1955, incorporating: Alexander McTavish Stalker, town of Mount Royal, John Malcolm McDougall, of Montreal, and Ian Caldcwell Stalker, of Westmount, all advocates, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers and agents, under the name of \"Wilks & Company Ltd.\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of January, 1955.C.E.CANTIN, 39437-o Deputy Attorney General.(A.G.10344-55) Wolfus & Adelstein Fur Mfg.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of February, 1955, incorporating: Solomon Wolfus, Isak Adelstein, both manufacturers, and John L.Liberman, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs and accessories, under the name of \"Wolfus & Adelstein Fur Mfg.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and into 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1955.i C.E.CANTIN, 39437-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 957 Lettres patentes supplémentaires (P.G.10176-55) Acme Molybdenite Mining Company Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatre février 1955, à la companie \"Acme Molybdenite Mining Company Limited\" (No Personal Liability), augmentant son capital de $3,000,000 à 86.000,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 3,000,000 actions de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10234-55) Bouchairc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du premier février 1955, à la compagnie \"Manoir Spaghetti Curb Service Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 29 octobre 1954, a) changeant son nom en celui de \"Bouchaire Inc\"; b) convertissant ses 100 actions ordinaires de 8100 chacune en 100 actions sans valeur nominale.Daté du bureau du Procureur général, le premier février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10309-55) Conro Development Corporation Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été- accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept février 1955, à la compagnie \"Consolidated Rochette Mines Ltd.\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 8 juillet 1936, sous le nom originaire de \"Rochette Gold Mines Company Limited\" (No Personal Liability), et par lettres patentes supplémentaires en date, respectivement, des 23 mai et 30 mai 1950, ces dernières changeant ledit nom originaire en celui de \"Consolidated Rochette Mines Ltd.\" (No Personal Liability), et par de nouvelles lettres patentes supplémentaires en date du 19 mars 1953, 1° réduisant son capital de $5,000,000 à $1,000,000: le capital-actions annulé étant divisé en 4,000,000 actions de $1; 2° augmentant tel capital de $1,000,000 à $5,-000,000: le capital-action additionnel étant divisé en 4,000,000 action de SI ; 3° changeant de nouveau le nom de la compagnie en celui de \"Conro Development Corporation Limited\" (No Personal Liability).Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.Supplementary Letters Patent (A.G.10176-55) Acme Molybdenite Mining Company Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act, and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February fourth, 1955, to the company \"Acme Molybdenite Mining Company Limited\" (No Personal Liability), increasing its capital stock from 83,000,000 to $6,000,000: the additional capital stock being divided into 3,000,000 shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10234-55) Bouchaire Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February first, 1955, to the company \"Manoir Sphaghetti Curb Service Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated October 29th, 1954, a) changing its name into that of \"Bouchaire Inc.\"; b) converting its 100 common shares of $100 each and into 100 shares without nominal value.Dated at the office of the Attorney General, this first day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10309-55) Conro Development Corporation Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act, and of Part I of the Quebec Companies' Act supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February seventeenth, 1955, to the company \"Consolidated Rochette Mines Ltd.\" (No Personal Liability), incorporated under the said Quebec Mining Companies' Act, by letters patent dated July 8th, 1936, under the original name of \"Rochette Gold Mines Company Limited\" (No Personal Liability), and by supplementary letters patent dated, respectively, May 23rd and May 30th, 1950, these latter changing the said original name into that of \"Consolidated Rochette Mines Ltd.\" (No Personal Liability), and by new supplementary letters patent dated March 19fh, 1953, 1.decreasing its capital stock from $5,000,000 to $1,000,000: thecan-celled capital stock being divided into 4,000,000 shares of $1 ; 2.increasing suchc apital stock from $1,000,000 to $5,000,000: the additional capital stock being divided into 4,000,000 shares of $1; 3.again changing the name of the company into that of \"Conro Development Corporation Limited\" (No Personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General. 958 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N\" 11 (P.G.10307-55) Forêt \u2014 Québec Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trois février 1955, à la compagnie \"Gobeil Lumber Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 20 mars 1947, changeant son nom en celui de \"Forêt \u2014 Québec Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le trois février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 CE.CANTIN.(P.G.10338-55) Maison Familiale St-Joscph Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du seize février 1955, à la \"Maison Familiale St-Joseph\", constituée en corporation en vertu de la troisième partie de ladite Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 26 juillet 1949, étendant ses pouvoirs en portant la valeur des biens immobiliers que ladite cotporation peut posséder de $1,000,000 à $3,000,000.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10273-55) Progressive Color & Chemical Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit février 1955, à la compagnie \"Progressive Color & Chemical Co.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 22 juillet 1953, changeant son nom en celui de \"Progressive Color & Chemical Co.Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le huit février 1955.L'Assistant-procureur général, \u2022 39437-0 C.E.CANTIN.(P.G.10033-55) St.Siméon Uranium Corporation (sans responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze février 1955, à la compagnie \"St.Siméon Uranium Corporation\" (sans responsabilité personnelle), augmentant son capital de $3,000,000 à $5,000,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,000,000 actions de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN.(A.G.10307-55) Forêt \u2014 Québec Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February third, 1955, to the company \"Gobeil Lumber Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated March 20th, 1947, changing its name into that of \"Forêt \u2014 Québec Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this third day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10338-55) Maison Familiale St-Joscph Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February sixteenth, 1955, to the \"Maison Familiale St-Joseph\", incorporated under Part III of the said Quebec Comp'anies' Act, by letters patent dated July 26th, 1949, extending its powers by carrying the value of the immoveable property which the corporation may possess from $1,000,-000 to $3,000,000.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10273-55) Progressive Color & Chemical Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February eighth, 1955, to the company \"Progressive Color & Chemical Co.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated July 22nd, 1953, changing its name into that of \"Progressive Color & Chemical Co.Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.(A.G.10033-55) St.Siméon Uranium Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act and Part I of the Quebec Companies' Act, Supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February fourteenth, 1955 to the company \"St.Siméon Uranium Corporation\" (No Personal Liability), increasing its capital stock from $3,000,000 to $5,000,000: the additional capital stock being divided into 2,000,000 shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol 87, No.11 959 (P.G.1029Ç-55) > Valor Lithium Mines limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires en date du deux février 1955, à la compagnie \"Valor Mines Limited\"' (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 29 septembre 1952, a) augmentant son capital de S3.000.000 à $5,000,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,000,000 actions de SI chacune; b) changeant son nom en celui de \"Valor Lithium Mines Limited\" (No Personal Liability).Daté du bureau du Procureur général, le deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39437-0 C.E.CANTIN; Vente pour taxes Canada \u2014 Province de Québec Municipalité du comté d'Ahgenteuil Avis public est par les présentes, donné par E.-M.Jones, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté d'Argentcuil, que les lots ou parties des lots ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique dans la salle d'audience du Palais de Justice, dans la ville de Lachute, dans ledit comté d'Argentcuil, étant l'endroit ou les sessions du conseil de comté sont tenues, JEUDI, le DOUZIÈME jour de MAI mil neuf cent cinquante-cinq (1955) à DIX heures du matin pour les taxes municipales et scolaires ducs aux municipalités ci-après mentionnées, à moins qu'elles ne soient payées entre mes mains avec tous les frais avant le jour de la vente.Municipalité de la paroisse de Saint-André Succession John Edisbury, Saint-André Est, comté d'Argentcuil, Québec \u2014 Partie du lot N° 464, paroisse de Saint-André, comté d'Argen-teuil.Un emplacement situé dans le village de Saint-André, comté d'Argenteuil, connu et désigné comme formant la partie est du lot 464 (p.e.464) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-André, comté d'Argenteuil, borné: au nord par la rue Saint-Gilles; au sud par une partie du lot N° 466; à l'est par le lot N° 463; à l'ouest par une partie dudit lot appartenant à Raphaël Larocque ou représentants; avec une maison de bois et autres bâtisses dessus érigées.Tel que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives, passives, apparentes ou occidtes attachées audit immeuble.Taxes municipales: $5.76; taxes spéciales pour les chemins, vidanges, protection contre les incendies: $8.03; arrérages, intérêts et honoraires: $15.50; taxes scolaires, spéciales, arrérages et intérêts : $42.14.Total : $71.43.Municipalité du village dé Carillon Succession A.Poulin, s/d Mme A.Mallette, Ottawa, Ont.\u2014 Les lots Nos 277 et 27S du village de Carillon, paroisse de Saint-André.Arrérages de taxes: S2.34.(A.G.10296-55) Valor Lithium Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act, and Part I of the Quebec Companies' Act, Supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated February second, 1955, to the company \"Valor Mines Limited\" (No Personal Liability), incorporated under the said Quebec Mining Companies' Act, by letters patent dated September 29th 1952, a) increasing its capital stock from $3,000,-000 to S5,000,000: the additional capital stock being divided into 2,000,000 shares of $1 each; b) changing its name into that of \"Valor Lithium Mines Limited\" (No Personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, this second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39437 Deputy Attorney General.Sale for Taxes Canada \u2014 Province of Quebec Municipality of the county of Argenteuil Public notice is hereby given by E.-M.Jones, Secretary-treasurer of the Municipal Council of the county of Argenteuil that the lots or parts of lots hereinafter mentioned will be sold by Public Auction in the Court Room of the Court House in the Town of Lachute, in the said county of Argenteuil, being the place where the sittings of the County Council are held, on THURSDAY the TWELFTH day of MAY, one thousand, nine hundred and fifty-five (1955) at TEN o'clock in the forenoon for Municipal and School taxes due to the Municipalities hereinafter described unless the same are paid to me with all costs before the day of the sale.Municipality of the parish of St.Andrews Estate John Edisbury, St.Andrews East, county of Argenteuil, Que.\u2014 Part of lot No.464 parish of St.Andrews, county of Argenteuil.An emplacement situated in the village of St.Andrews in the county of Argenteuil known and designated as forming the east part of lot 464 (P.E.464) of the official cadastre and book of reference for the parish of St.Andrews, county of Argenteuil, bounded on the north by St.Gilles Street; on the south by part of lot No.466; on the east by lot No.463; on the west by part of the said lot belonging to Raphaël Larocque or representatives, with a wooden house and other buildings erected thereon.As the whole is found with the active and passive servitudes apparent or occult attached to the said immovable.Municipal taxes; $5.76; special taxes for roads, garbage, county and Fire protection: $8.03; arrears, interests and fees: $15.50; school taxes, special, arrears and interest: $42.14.Total: $71.43.Municipality of the village of Carillon Estare A.Poulin, c/o Mrs.A.Mallette, Ottawa, Out \u2014Lots nos 277 and 278 of the village of Carillon, in the parish of St.Andrews, arrears of taxes: $2.34. 960 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N6 11 Municipalité du canton de Wentworth Geo.Finlayson, adresse inconnue.\u2014 Les subdivisions Nos 578, 579, 602 et 603 du lot 11A du rang 10 du canton de Wentworth.Taxes municipales: $1.80; taxes scolaires: $0.78; frais: $0.50.Total: $3.00.Inconnu.\u2014 La subdivision N° 90 du lot 11 A, rang 10, canton de Wentworth, Taxes municipales: $0.90; taxes scolaires: $0.35.Total: $1.25.Allan J.Loughrin, adresse inconnue.\u2014 Subdivision N° 277 du lot 8, rang 11, canton de Wentworth.Taxes municipales: $5.38; taxes scolaires: $2.00; frais: $1.00.Total: $8.38.W.Reinhold, adresse inconnue.\u2014 Subdivisions nos 634, 635, 636, 637, 638 du lot 11B, rang 10, canton de Wentworth.Taxes municipales: $4.75; taxes scolaires: $3.00; frais: $1.00.Total: $8 75.Inconnu.\u2014Subdivision N° 802 du lot 10, rang 10, canton de Wentworth.Taxes municipales: $2.76; taxes scolaires: $0.54; frais: $0.50.Total: $3.80.F.S.Prosser, adresse inconnue.\u2014 Subdivision N° 803 du lot 10, rang 10, canton de Wentworth.Taxes municipales: $2.76; taxes scolaires: $0.54; frais: $0.50.Total: $3.80.L.M.Gray, adresse inconnue.\u2014 Subdivisions 804,805 du lot 10, rang 10, canton de Wentworth, avec bâtisses dessus érigées.Taxes municipales: $40.00; taxes scolaires: $10.05; frais: $2.00.Total: $52.05.F.H.Goodfellow.\u2014 Subdivisions nos 806, 807 du lot 10, rang 10, canton de Wentworth.Taxes municipales: $4.50; taxes scolaires: $1.05; frais: $0.50.Total: $6.05.J.C.R.Tomax \u2014 Subdivision N° 810, du lot 10, rang 10, canton de Wentworth.Taxes municipales: $2.76; taxes scolaires: $0.54; frais: $0.50.Total: $3.80.Municipalité du canton de Howard John Alexander, Leslie Hastee, Morin Heights, Québec \u2014 Partie du lot 16, rang 1, canton de Howard.Un certain emplacement de forme irrégulière, étant une partie du lot numéro seize du permier rang, canton de Howard, comté d'Argenteuil, mesurant deux cents pieds en front sur la route nationale, cent cinquante pieds sur le côté est, deux cents pieds sur le côté nord et deux cents pieds sur le côté ouest, borné du côté sud par la route nationale numéro trente, du côté nord par le lot dix-sept, du côté ouest par Paul Larente, du côté est par le résidu du même lot seize, ledit résidu mesurant 150 pieds pour rejoindre la ligne de comté.Le tout avec une maison et un hangar de bois dans leur état présent, comprenant aussi tous les meubles et effets mobiliers y contenus ainsi que le droit de passage permanent servant à aller puiser de l'eau d'un ruisseau se trouvant sur le terrain du vendeur.(Les dimensions indiquées ci-dessus sont de la mesure anglaise, plus ou moins).Telle que ladite propriété se trouve présentement avec tous ses droits, membres et appartenances, sans exception ou réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.Taxes municipales: $56.45; intérêts, avis et recherches: $11.00; taxes scolaires: $39.20; intérêts: $5.00.Total: $111.65.Firmin Langlais, 2463 McGill, ville Jacques-Cartier.\u2014 Le lot P.6, rang 3, canton d'Howard, Un emplacement faisant partie du lot de terre désigné sous le numéro six (6 Pt.) dans le troisième rang du canton d'Howard, comté d'Argenteuil, et borné d'un côté par la propriété de Baker ou représentants d'un deuxième côté par la propriété The municipality of the township of Wentworth Geo.A.Finlayson, address, unknown \u2014 Subdivisions nos 578; 579, 602, 603 of lot 11A of range 10 of the township of Wentworth.Municipal taxes: $1.80; school taxes: $0.70; costs: $0.50.Total: $3.00.Unknown \u2014 Subdivision no.90 of lot 11 A, range 10, township of Wentworth.Municipal taxes: $0.90; scoll taxes: $0.35; Total: $1.25.Allan J.Loughrin address, unknown \u2014 Subdivision No.277 of lot 8, range 11, township of Wentworth.Municipal taxes: $5.38; school taxes : $2.00 ; costs : $1.00.Total : $8.38.W.Reinhold, address unknown \u2014 Subdivisions nos 634, 635, 636, 637, 638 of lot 1 IB range 10, township of Wentworth.Municipal taxes: $4.75; school taxes: $3.00; costs: $1.00.Total: $8.75.Unknown \u2014 Subdivision No.802 of lot 10, range 10» township of Wentworth.Municipal taxes: $2.76; school taxes: $0.54; costs: $0.50.Total: $3.80.F.S.Prosser, address unknown 1\u2014 Subdivision No.803 of lot 10, range 10, township of Wentworth.Municipal taxes: $2.76; school taxes: $0.54; costs: $0.50.Total: $3.80.L.M.Gray, address unknown \u2014 Subdivisions 804, 805 of lot 10, range 10, township of Wentworth, with buildings thereon erected.Municipal taxes: $40.00; school taxes: $10.05; costs: $2.00.Total: $52.05.F.H.Goodfellow \u2014 Subdivisions nos 806, 807 of lot 10, range 10, township of Wentworth.Municipal taxes: $4.50; school taxes: $1.05; costs: $0.50.Total: $6.05.J.C.R.Tomax \u2014 Subdivision No.810, of lot 10, range 10, township of Wentworth.Municipal taxes: $2.76; school taxes: $0.54; costs: $0.50.Total: $3.80.Municipality of the township of Howard John Alexander, Leslie Hastee, Morin Heights, Que.\u2014 Part of lot 16, range 1, township of Howard.A certain emplacement of irregular form, being part of lot number sixteen, in the first range, in the township of Howard in the éounty of Argenteuil, measuring two hundred feet frontage on National Road, one hundred and fifty feet on East side, two hundred feet in North side, and two hundred feet on West side; bounded on the South side by National Road number thirty, on the north side by lot seventeen, on the West side by Paul Larcnte, on the East side by residue of the same lot sixteen, said residue measuring 150 feet to join the county line.The whole with wooden house and shed in their present state of repair, including also all furniture and movables therein contained with also permanent right-of-way to get water from the spring on the seller's ground (The above measurements are English measure and are more or less) as the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances, without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Municipal taxes: $56.45; interest, notices and searches: $11.00; school taxes: $39.20; interest: $5.00.Total: $111.65.Firmin Langlais, 2463 McGill, town of Jacques-Cartier\u2014 Lot Pt.6, range 3, township of Howard.An emplacement forming part of lot of land designated under number six (Pt.6) in the third range of the township of Howard, county of Argenteuil, and bounded on one side by the property of Baker or representatives, on the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 961 d'Oscar Dcslauricrs, d'un troisième côté par les terres de Philias (îuéncttc, d'un quatrième côté par le résidu dudit lot N° 6 appartenant aux représentants de Paquette, soit jusqu'à un arpent au sud de la Chute servant de décharge au Lac Long; plus exactement tout ce que ledit Philias Guénctte avait acquis par la vente enregistrée au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil sous le numéro -18650.Ainsi que le tout se trouve actuellement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble.Taxes scolaires: §45.70; intérêt: §6.31; recherches: §2.50.Total: §5-1.51.Firmin Langlais, 2403 McGill ville Jacques-Cartier \u2014 Le lot P.7P» rang 3, canton d'Howard.Un immeuble situé à St-Adolphe d'Howard, comté d'Argenteuil, pris à même le lot de terre désigné sous le numéro sept B dans le troisième rang, (7B, R.111 Pt) au cadastre officiel du canton d'Howard.L'immeuble présentement vendu mesure trois cents pieds (300') de largeur en avant le long du chemin public conduisant de Morin Heights à Lac des Seize Iles et trois cents pieds (300') de largeur en arrière dans la ligne sud sur cent pieds (100') de profondeur dans la ligne ouest le long du chemin public conduisant à Montfort et cent pieds (100') de profondeur dans la ligne est; mesure anglaise.L'Immeuble présentement vendu est borné en avant vers le nord audit chemin public conduisant de Morin Heights au Lac des Seize Iles, d'un côté vers l'ouest audit chemin public conduisant àMontford,de l'autre côté vers l'est et en arrière vers le sud au reste du même lot No 7B troisième rang, appartenant au vendeur.Tel que le tout se trouve actuellement avec les servitudes attachées audit immeuble.A même l'immeuble présentement vendu et plus haut désigné se trouve inclus la partie précédemment vendue par le présent vendeur au présent acquéreur par acte de vente passé devant le notaire soussigné le 18 novembre, 1917 et enregistré sous le N° 64535.Taxes scolaires: 85.90; intérêts, avis: §1.60; recherches: §2.50.Total: S10.00.Marcel Clément, adresse inconnue \u2014 Le lot P.21, rang 3, canton d'Howard.Un terrain situé en la paroisse de Saint-Alphonse d'Howard, dans le troisième rang du canton d'Howard, faisant partie du.lot de terre numéro vingt-et-un (Pt 21) du cadastre officiel dudit canton, mesurant soixante-quinze pieds (75') dans ses lignes nord et sud, et cent quarante pieds (140') dans les lignes est et ouest, mesure anglaise, et borné de tous côtés par le reste dudit lot vingt-ct-un appartenant au vendeur.A noter que la ligne nord est parallèle à la ligne sud du terrain d'un nommé Légaré et en est distante de trente-quatre pieds (34').La ligne est du même terrain est distante de deux cents pieds (200') du chen\\in du Roi à son bout nord, et de deux cent trente-cinq pieds (235') du même chemin à son bout sud.La maison sise sur ce terrain a été construite par l'acquéreur et lui appartient.Avec droit de passage à pied, en voiture ou autrement à perpétuité sur une lisière dudit lot vingt-et-un de trente-quatre pieds de largeur longeant la ligne sud du terrain d'un nommé Légaré à partir du chemin du Roi, en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du terrain sus-décrit, une servitude réelle et perpétuelle étant, par les présentes, créée sur cette dite lisière de terrain pour les besoins et l'utilité du terrain sus-décrit et présentement vendu.Taxes municipales: S24.25; inté- second side, by the property of Oscar Deslauriers, on a third side, by the farms of Philias Guénctte, on a fourth side, by the residue of the said lot No.6, belonging to the representatives of Paquette, albeit to an arpent south of the falls serving as a discharge for Lake Long; to be more exact, all that the said Philias Guénctte had acquired by the registered sale at the registration office of the county of Argenteuil, under number 48650.As the whole is to be found presently, with the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immoveable.School taxes: §45.70; interest: 86.31; searches: 82.50.Total: 854.51.Firmin Langlais, 2463 McGill, town of Jacques-Carticr \u2014.Lot Pt.7B, range 3, township of Howard.An immoveable situate at St.Adolphe of Howard, county of Argenteuil, taken along the same lot of land designated under number seven B in the third range, (7B, R.Ill Pt.) on the official cadastre of the township of Howard.The immoveable presently sold measures three hundred feet (300') in width in front along the public highway leading from Morin Heights to Lake des Seize- lies and three hundred feet (300') in width in rear on the south line by one hundred feet ( 100') in depth on the west line along the public highway leading to Montfort and one hundred feet (100') in depth on the East line; English measure.The immoveable presently sold is bounded in front on the north by the said public highway leading from Morin Heights to Lake des Seize lies, on one side, on the west, to the said Public highway leading to Montfort, on the other side on the east and in rear, on the south by the remainder of the same lot No.7B, third range, belonging to the seller.As the whole is to be found presently with the servitudes attached to the said immoveable.Along with the ommo-vcable now sold and above designated is included that part previously sold by the present seller to the present purchaser by deed of sale passed before the undersigned notary on November 18th, 1947, and registered under No.64535.School taxes: 85.90; interests, notices: 81.60; searches: S2.50.Total: 810.00.Marcel Clément, address unknown \u2014 Lot Pt.21, range 3, township of Howard.A plot of land situate in the parish of St.Adolphe of Howard, in the third range of the township of Howard, forming part of lot of land number twenty-one (Pt.21) of the official cadastre of the said township, measuring seventy-five feet (75') in its northerly and southerly lines, and one hundred and forty feet (140') in its easterly and westerly lines, English measure, and bounded on all sides by the remainder of the said lot twenty-one belonging to the seller.It is to be noted that the northerly line is parallel to the southerly line of the land of one named Légaré and is distant from same by thirty-four feet (34').The easterly line of the same p^ot of land is distant by two hundred feet (200') of the King's highway at its northern point, and by two hundred and thirty-five feet (235') of the same road at its southern point.The house situate upon this plot of land was erected by the purchaser and belongs to him.With right of way on feet, by carriage or otherwise in perpetuity, along a strip of the said lot twenty-one by thirty-four feet in width skirting the southerly line of the land of one named Légaré from the King's highway, going towards the west as far as the westerly line of the land above described, a real and perpetual servitude being, by these 9G2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 rôt, avis, recherches: $3.00; taxes scolaires: $18.85; intérêt: $1.75.Total: S 17.85.Municipalité de Mille Isles Mme II.Kees, 0701, Chemin Côte St-Luc, Montréal, Que \u2014 N° cadastral P.89, subdivision N° 19, Côte Ste-Angélique S.O., municipalité «le Mille Isles, enregistrement N° 72597.Solde des taxes municipales: $9.87; taxes scolaires: 821.00.Tozal: $31.53.Dame Catherine Twee-dale, épouse séparée de biens de Harold Kees, partie du lot 89.municipalité de Mille Isles, mesurant 100' x 150' de profondeur, bornée en front dans une ligne est par un chemin privé et dans une direction nord par un lot vacant de 100' de largeur, demeurant la propriété du vendeur, entre un lot vendu à J.B.Twcedale, et en arrière dans une direction ouest par le lot 90 et dans une direction sud par le résidu du lot 89, la propriété du vendeur.Mme A.Maclehouse, 200 avenue Montcalm, (îranby, Que.\u2014 No cadastral partie 192, côte Stc-Marguerite, municipalité de Mille Isles, enregistrement No 50373.Taxes municipales: $3.41; taxes scolaires: SU).17.Total: $13.58.A.Maclehouse, partie 192, 79' en front, 58' en arrière, 55' de profondeur à l'ouest et 79' de profondeur à l'est, bornée en front par le chemin public, en arrière au nord et «l'un côté à l'est par des parties dudit lot N° 192 appartenant au vendeur et de l'autre côté par une partie dudit lot appartenant à R.C.Copping, mesure anglaise.Ralph Parker, 0004, 14e avenue, Rosemont, Que.\u2014 No cadastral partie 84, Côte Sainte-Angélique, S.O., municipalité de Mille Isles, enregistrement N° 73703.Taxes municipales: S4.88; taxes scolaires: $5.88.Total: S10.70.Ralph Parker, partie 84, 90' de largeur apr 200' de profondeur, borné au nord par le Lac Fiddler et à l'est par la propriété vendue à Mme A.Morrsan (Enr.N° 00017) et à l'ouest par le terrain possédé par Mme L.P.Hunter et Mme Sort (enr.N° 08540) et au sud par un chemin privé conduisant à la roule principale.Municipalité de la paroisse de St-Jérusalem Ivan Holland, Lachute, Que.\u2014 Parties des lots 1097, 1098 et 1099 paroisse de St-Jérusalem.1° Ce certain morceau de terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jérusalem d'Argenteuil faisant partie du lot numéro mille six cent quatre-vingt-dix-huit (p.1098), mesurant cinquante-cinq pieds de largeur par deux cents pieds de profondeur, mesure anglaise, borné au nord par le bord d'une rigole se trouvant sur ledit lot, à l'ouest par cette portion décrite au second paragraphe, au sud par la rivière Nord par la ligne d'eau basse, à l'est partiellement par la propriété d'Ernest H.Copeland et partiellement par la propriété décrite au troisième paragraphe, avec les bâtisses dessus érigées.2° Ce certain morceau de terrain connu et désigné aux plan et livre «le renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argenteuil comme étant le coin ouest du lot numéro seize cent quatre-vingt-dix-huit (1698) et le coin sud-est du lot numéro seize cent quatre-vingt-dix-sept (1097); ladite parcelle de terrain formant une figure triangulaire, borné au sud par la rivière Nord, à l'est par cette portion dudit lot 1098 appartenant à l'acheteur, au nord par le résidu desdits lots 1098 et 1097, la ligne nord partant au presents, created upon this said strip of land for the needs and use of the land above described and presently sold.Municipal taxes: $24.25; interest, notices, searches: $3.00; school taxes: 818.85; interest: $1.75.Total: $47.85.The municipality of Mille Isles Mrs.H.Kecs, 0701 Côte St.Luke Road, Montreal, Que.\u2014Cadastral No.Pt.89 subdivision No.19, Côte St.Angélique S.W.municipality Mille Isles.Registration No.72597.Balance of municipal taxes: S9.S7; school taxes: $21.06.Total: $31.53.Dame Catherine Twccdale wife separate as to property of Harold Kees, part of lot 89, municipality of Mille Isles, 100' x 150' deep.Bounded in front in an easterly line by a private road and on the northerly direction by a 100' wide vacant lot, remaining the property of the vendor, between a lot sold to J.B.Twccdale and in rear in a westerly direction by lot 90 and in a southerly direction by the remainder of lot S9, the property of the vendor.Mrs.A.Maclehouse, 200 Montcalm Avenue, (îranby, Que.\u2014 Cadastral No.part 192, Côte St.Marguerite, municipality of Mille Isles, registration No.50373.Municipal taxes: $3.41; school taxes: $10.17.Total: $13.58.A.Made-house part 192, 79' in front; 58' in back; 55' in depth on the west; 79' in depth on the east.Bounded in front by the public road, at the back to the north and on one side to the east by parts of said lot No.192 belonging to the vendor, and on the other side by part of the said lot belonging to R.C.Copping (English measure).Ralph Parker, 0004 14th Ave.Rosemount, Que.\u2014 Cadastral No part 84, Côte St.Angélique S.W.municipality of Mille Isles, registration No.73703.Municipal taxes: $4.88; school taxes: $5.88.Total: $10.70.Ralph Parker part 84, 90' wide by 200' deep, bounded on the north by Fiddler's Lake and on the East by property sold to Mrs.A.Morrsan (Reg.No.(50017) and on the west by land owned by Mrs.L.P.Hunter and Mrs.Short (Beg.No.68546) and on the south by a private road leading from the main highway.Municipality of the parish of St.Jerusalem Ivan Holland.Lachutc, Que.\u2014 Parts of lots 1697, 1698, 1699.Parish of St.Jerusalem.1.That certain piece of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the parish of St.Jerusalem d'Argentcuil, as forming part of the lot number one thousand six hundred and ninety-eight (Pt.1698) measuring fifty-five feet in width by a depth of two hundred feet, English measure; bounded north by the edge of a gulley of the said lot; west by that portion described in the second paragraph; south by the North River, at the low water mark; east partly by the property of Ernest H.Copeland and partly by the property described in the third paragraph; with the buildings thereon erected; 2.That certain piece of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the parish of St.Jerusalem d'Argenteuil, as being the west corner of the lot number sixteen hundred and ninety-eight (1698) and the south east corner of lot number sixteen hundred and ninety-seven (1697); said parcel of land forming a triangular figure bounded south by the North River; cast by that portion of said lot 1698 belonging to the purchaser, north by the remainder of said lot 1698 and 1697; the north QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 903 coin nord-ouest dudit terrain de l'acheteur en allant dans une direction sud-ouest jusqu'à la rivière Nord à seize pieds à l'est du nord du ruisseau.3° Ce certain morceau de terrain faisant partie du lot connu et désigné sous le numéro seize cent quatre-vingt-dix-neuf (1699) aux plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse de St-Jérusalem d'Argenteuil, borné en front par une ligne située à cent soixante-dix pieds de la rivière Nord, en arrière et à l'est par le résidu dudit lot 1699 et à l'ouest par le terrain décrit au premier paragraphe, contenant soixante-trois pieds de largeur par deux cent trente-cinq pieds de profondeur, le tout mesure anglaise.Taxes municipales et les taxes 1955: $27.50; intérêts et avis: $1.20; taxes scolaires: $40.59.Total: $09.29.Municipalité de Morin Heights J.E.Brown.\u2014 Partie du lot N° 37A, rang 2, canton Morin, terrain et bâtisses.2}4 acres environ, morceau irrégulier ayant front sur \"Main Morin\", chemin Saint-Sauveur, en arrière par la rivière Simon, à l'ouest par d'autres portions du lot 37A et à l'est par d'autres portions du lot 37A.Taxes municipales: $85.01; taxes scolaires: $93.00; frais et intérêts: $8.25.Total: $180.80.Wm.Decelles.\u2014 Partie du lot N° 55, rang 1, canton Morin, terrain et bâtisses, 1 acre environ ayant front à l'est sur le chemin principal de Lachute, route 30, au nord, au sud et à l'ouest par d'autres portions du lot 55.Taxes municipales: $9.41; taxes scolaires: $15.49; intérêts et frais: $3.50.Total: $28.40.H.W.Fisher \u2014 Partie du lot N° 30, rang 2, canton Morin, terrain et bâtisses, \\4 d'acre environ ayant front au nord par un chemin privé allant à l'est et à l'ouest de la 0e avenue, à l'ouest par d'autres portions du lot 36 possédées par Mme Copple, au sud par d'autres portions du lot 30 possédées par Mme Copple et à l'est par d'autres portions du lot 30 possédées par Stanley Barth.Taxes municipales: $21.50; taxes scolaires: $02.58; intérêts et frais: $3.60.Total: $87.68.Mme H.W.Fisher.\u2014Partie du lot n° 36, rang 2, canton Morin.Le terrain seulement couvert par l'acte 7562S enregistré le 5 août 1953.Taxes municipales: $2.59; taxes scolaires: $1.93; intérêts et frais : $2.46.Total: S0.98.Garage Girard \u2014 Subdivision 113 du lot 38A, rang 2, canton Morin, terrain et bâtisses, ayant front sur l'artère principale Morin, chemin Saint-Sauveur, couvert par une sous-section, enregistrement de la subdivision 113, article 2175 C.C.Taxes municipales: $140.75; taxes scolaires: $217.28 ; intérêts et frais : $8.55.Total : $366.58.Capt.M.McKcen \u2014 Lot 46A rang 1, canton Morin, terrain seulement ayant front sur le chemin Lachute, route 30, borné au nord par le lot 46, rang 2, à l'est par le lot 45A, rang 1, à l'ouest par le lot 47A, rang 1, au sud par le lot 46B, rang 1, possédé par W.J.Seale.Taxes municipales: $13.50; taxes scolaires: $14.50; intérêts et frais: $3.00.Total: $31.00.Capt.M.McKeen \u2014 Lot 47A, rang 1, canton Morin, terrain et bâtisses, borné au nord par le lot 47, rang 2, à l'ouest par le 'ot 48, rang 1, à l'est par le lot 46A, au sud par I c lot 47B, rang 1, possédé par W.J.Seale.Taxes municipales: $93.58; taxes scolaires: $244.58; intérêts et frais: $4.95.Total: $343.11.Col.N.Vaughan \u2014 Partie du lot 36, rang 3, canton Morin, terrain et bâtisses, bornée à l'est et au nord par le chemin Saint-Adolphe, route 30, à l'ouest et au sud par d'autres portions line starting at the north west corner of said purchaser's land going in a south west direction to the North River at sixteen feet east of the north of the creek.3.That certain piece of land forming part of the lot known and designated under the number sixteen hundred and ninety-nine (1099) upon the official cadastral plan and book of reference of the said parish of St.Jerusalem d'Argenteuil, bounded in front by a line at about one hundred and seventy feet from the North River, in rear and cast by the remainder of the said lot 1099 and west by the land described in the first paragraph, containing in width sixty-three feet in a depth of two hundred and thirty-five feet, the whole English measure.Municipal taxes and 1955 taxes: $27.50; interest and notices: S 1.20; school taxes: $40.59.Total: $69.29.Municipality of Morin Heights J.E.Brown \u2014 Part of lot No.37A, range 2, township of Morin.Land and buildings.About 2}4 acres irregular piece, fronting on Main Morin, St.Sauveur Road; in rear by Simon River; west by other portions of lot 37A; and east by other portions of lot 37A.Municipal taxes: $85.61; school taxes: $93.00; costs and interest: $8.25.Total: $180.80.Wm.Decelles \u2014 Part of lot No.55, range 1, township of Morin.Land and buildings.About 1 acre, cast fronting on Main Lachute highway route 30, on north, south and west by other portions of lot 55.Municipal taxes: $9.41; school taxes: $15.49; interest and costs: $3.50; Total: $28.40.H.W.Fisher \u2014 Part of lot No.30, range 2, township of Morin.Land and buildings.About 14 acre fronting on north by a private road running cast and west off 6th Avenue; on west by other portions of lot 36 owned by Mrs.Copple; on south by other portions of lot 36 owned by Mrs.Copple; and on cast by other portions of lot 36 owned by Stanley Barth.Municipal taxes: $21.50; school taxes: $62.58; interests and costs: $3.00.Total: $87.08.Mrs.H.W.Fisher \u2014 Part of lot No.36 range, 2, township of Morin.Land only covered by deed 75628, registered 5th August 1953.Municipal taxes: $2.59; school taxes: $1.93; interest and costs : $2.46.Total : $6.98.Garage Girard \u2014 Subdivision 113, of lot 38A range 2, township of Morin.Land and buildings, fronting on Main Morin, St.Sauveur Road, covered by a subsection, registration of subdivision 113, article 2175 C.C.Municipal taxes: $140.75; school taxes: $217.28; interest and costs: S8.55.Total: $366.58.Capt M.McKeen \u2014 Lot 46A range 1, township of Morin.Land only, fronting on Lachute highway route 30, bounded on north by lot 46, range 2; east by lot 45A, range 1; west by lot 47A, range 1; south by lot 4GB, range 1, owned by W.J.Scale.Municipal taxes: $13.50; school taxes: $14.50; interest and costs: $3.00.Total: $31.00.Capt.M.McKeen \u2014 Lot 47A, range 1, township of Morin.¦ Land and buildings, bounded on north by lot 47, range 2; on west by lot 48, range 1 ; on cast by lot 40A; on south by lot 47B, range 1, owned by W.J.Seale.Municipal taxes: 893.58; school taxes: $244.58; interest and costs : S4.95.Total : 8343.11.Col.N.Vaughan \u2014 Part of lot 36, range 3, township of Morin.Land and buildings, bounded on east and north by St.Adolphe Road, route 30; on west and south by other portions of lot 964 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 du lot 36 possédées par Henri Bélisle.Taxes municipales: S28.S2; taxes scolaires: 338.51; intérêts et frais : 82.95.Total : 809.28.Donné à Lachute, Que., ce 3c jour de mars 1955.Conseil municipal du comté d'Argenteuil, (Sceau) Par le Secrétaire-trésorier, 39409-10-2 E.-M.JONES.30 owned by Henri Bélisle.Municipal taxes: S28.82; school taxes: 838.51; interest and costs: 82.95.Total: 809.28 Given at Lachute, Que., this 3rd dav of March 1955.Municipal Council of the county of Argenteuil, (Seal) E.-M.JONES, 39409-10-2 Per Secretary-Treasurer.Assemblée AVIS Avis est, par les présentes, donné que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie \"Quebec Central Railway Company\" sera tenue aux bureaux de la compagnie \"Canadian Pacific Railway Company\", Montréal, Canada, mercredi, le 20c jour d'avril 1955, à onze heures du matin, pour l'élection de deux directeurs représentant les obligataires et, en général, pour la transaction de toute autre affaire.Les actionnaires enregistrés le 10c jour de mars 1955 peuvent assister et voter à l'assemblée.Daté à Montréal, Canada, le 1er jour de mars 1955.Le Secrétaire, 39452-11-3 C.NIDEROST.Meeting NOTICE Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of Quebec Central Railway Company will be held at the Offices of the Canadian Pacific Railway Company, Montreal, Canada, on Wednesday, the 20th day of April, 1955, at the hour of eleven o'clock in the forenoon, for the election of two Directors representing the Security Holders and, for the transaction of business generally.Stockholders of record on the 16th day of March, 1955, may attend and vote.Dated at Montreal, Canada, this 1st day of March, 1955.C.NIDEROST, 39452-1 l-3-o Secretary.- Avis divers (P.G.3082-51) Hi mico Ltd.Règlement numéro 3A \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes décrété comme un règlement de \"Humico Ltd.\" ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à cinq, de manière que le bureau de direction de la compagnie soit, composé dorénavant de cinq directeurs.2° Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icclui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.\" Décrété le troisième jour de janvier 1955.Certifié conforme.Le Secrétaire, 39440 WM.JOHNSTON.(P.G.5482-53) Eleven & Twelve Island Club Inc.Extrait des règlements généraux de la corporation nommée ci-dessus concernant une augmentation du nombre de ses directeurs de trois à cinq: \"III \u2014 Directeurs \u2014 Un bureau de direction composé de pas plus que cinq directeurs, dont trois formeront quorum, sera élu annuellement par les membres à leur assemblée annuelle.\" Certifié vraie copie.Le Commis et secrétaire, 39447-0 ROYAL D.POTTER.Miscellaneous Notices (A.G.3082-51) Humico Ltd.By-law number 3A \"Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"Humico Ltd.\", as follows: 1.The number of Directors of the company be and the same is hereby increased from three to five, so that the Board of Directors of the company shall hereafter be composed of five Directors.2.Three Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.AH prior By-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this By-law.\" Enacted on the third day of January, 1955.Certified true WM.JOHNSTON, 39440-o Secretary.(A.G.5482-53) Eleven & Twelve Island Club Inc.Extract from the general by-law of the above named corporation, concerning an increase in the directorate thereof from three to five: \"III \u2014 Directors \u2014 A board of not more than five Directors, of which three shall constitute a quorum, shall be elected annually by the members at their annual meeting.\" ¦ Certified true copy.' - ROYAL D.POTTER, 39447-0 Clerk and Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 905 (P.G.3150-49) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le vingt-huit février 1955, les modification apportée aux règlements de \"Le Bien-Être des Immigrants\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le premier mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province.39441-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.2559-50) Month bal Fast Phint Limited 9500 Boulevard St-Laurent, Montréal, P.Q.Amendement No.1 \"Il est résolu que les sous-paragraphes A et E du règlement N° 23 sont amendés, réduisant le nombre de directeurs de la companie de quatre à trois; deux directeurs formeront quorum pour transiger les affaires; aucune résolution ne sera adoptée à moins qu'elle ne soit approuvée par au moins deux directeurs.\" Adopté ce 2ième jour de novembre 1954.Témoin: Le sceau corporatif de la compagnie.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 39442-0 J.FRYML.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est.donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé, le sept mars 1955, le changement de nom de \"L'Association Catholique des Institutrices Laïques de Saint-Jean, Inc.\", dont la constitution en syndicat professionnel, sous le nom originaire de \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 16, Inc.\" a été autorisé le 17 juin 1943, avec siège social à Saint-Jean, P.Q., en celui de \"Syndicat des Professeurs Catholiques de Saint-Jean\", et ce conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le huit mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39443-Q JEAN BRUCHÉSI.(P.G.9255-50) Knowlton Investments Limited Règlement spécial \"A\" Un règlement pour diminuer le nombre des directeurs de la compagnie de cinq à trois.Attendu que le nombre des directeurs de la compagnie est maintenant de cinq et il est opportun et dans l'intérêt de la compagnie que le nombre en soit diminué; En conséquence, qu'il soit décrété comme le règlement spécial \"A\" de la compagnie: Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de cinq à trois, dont deux formeront quorum.Certifié vraie copie du règlement spécial \"A\" de la compagnie tel que décrété à une assemblée du bureau des directeurs de la compagnie dûment convoquée et tenue le 10 décembre 1954 (A.G.3150-49) Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on the twenty-eighth day of February 1955.the amendments to the by-laws of \"Le Bien-Etre des Immigrants\", and such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the first day of March, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39441 Under Secretary of the Province.(A.G.2559-50) Montreal Fast Print Limited 9500 St-Lawrence Boulevard, Montreal, P.Q.Amendment No.1 \"Resolved that By-law number 23 subsections A and E are amended, decreasing the number of the Directors of the Company from four to three; two directors to form a quorum for the transaction of business; no resolution to be adopted unless concurred in by at least two directors.\" Adopted this 2nd day of November, 1954.Witness: The corporate seal of the company.Certified true copy.J.FRYML, 39442-o Secretary.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized, on March seventh, 1955, the change of name of \"L'Association Catholique des Institutrices Laïques de Saint-Jean, Inc.\", whose incorporation into a professional syndicate under the-original name of \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District No.16, Inc.\" was authorized on June 17th, 1943, with head office at Saint-John, P.Q., into that of \"Syndicat des Professeurs Catholiques de Saint-Jean\", and such, pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act R.S.Q., 1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, on March eighth, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39443 Under Secretary of the Province.(A.G.9255-50) Knowlton Investments Limited Special by-law \"A\" A by-law to decrease the number of the company's directors from five to three.Whereas the number of the company's directors is now five and it is expedient and in the interests of the company that the number should be reduced; Now therefore be it enacted as special by-law \"A\" of the company: That the number of the company's directors be and the same is hereby reduced from five to three, of whom two shall form a quorum.Certified a true copy of special by-law \"A\" of the company as enacted at a meeting of the board of directors duly called and held on December 10th, 1954, and as approved by the vote 966 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 7nars 1955, Tome 87, N° 11 et tel qu'approuvé par le vote de toutes les actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée pour considérer le règlement et tenue le même jour.Témoin: Ma signature et le sceau corpora!if de la compagnie à Montréal, ce 21e jour de février 1955.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 39448 BOSS.T.CLARKSON.(P.G.10400-55) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation de assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a, le 14 mars 1955, approuvé les règlements de \"Canadian Pacific Recreation Club, (Montreal) Inc.\", tels qu'adoptés et amendés aux assemblées générales spéciales tenues respectivement le 6 avril 1938 et le 5 février 1941, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 15e jour de mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39456 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Stc-Félicité\", en date du huit février 1955, dont le siège social *st situé à Sainte-Félicité, dans le comté de LTslct, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le quatorze février 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39462-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat Catholique et National des Travailleuses de Chemises de Bcrthier\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le douze janvier 1955.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Berthicrville, dans le comté de Berthier.Le Sous-secrétaire de la Province, 39464-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Diplômés en Technologie Médicale de la Province de Québec\", pour l'étude, la défense et le développement, des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le quinze mars 1955.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Québec, dans le district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la Province, 39465-o JEAN BRUCHÉSI.of all of the shares represented by the shareholders present at a special general meeting called for considering the by-law and held the same day.Witness my hand and the corporate seal of the company at Montreal this 21st day of February, 1955.(Seal) ROSS T.CLARKSON, 39448-0 Secretary-Treasurer.(A.G.10400-55) Notice is hereby given that, upon the recommandation of the Deputy Attorney General, the by-laws of \"Canadian Pacific Recreation Club, (Montreal) Inc.\", as adopted and amended at the special general meetings held respectively on April 6th, 1938 and on February 5th, 1941, were approved on March 14th, 1955, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary this 15th dav of March, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39450-o Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Ste-Félicité\", under the date eighth day of February 1955, whereof the head oflice is at Sainte Félicité, in the county of LTslct, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fourteenth day of February 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39402 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat Catholique et National des Travailleuses de Chemises de Bcrthier\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on January twelfth, 1955.The principal place of business of the said professional syndicate is at Berthicrville, in the countv of Bcrthier.JEAN BRUCHÉSI, 39404 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Diplômés en Technologie Médicale de la Province de Québec\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on March fifteenth, 1955.The principal place of business of the said professional syndicate is at Quebec, in the judicial district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 39405 Uiuler Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 967 (P.G.11537-54) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'Honorable Secrétaire de la Province a, le 24 janvier 1955, approuvé les règlements de \"Pointe Claire Civic Action League\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 25e jour de janvier 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39463 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux «lis-positions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi II George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le onze mars 1955, la fin de l'existence corporative de \"L'Association des Poseurs de Lattes Métalliques de Montréal\", dont la constitution en syndicat professionnel a été autorisée le 3 avril 1930, avec son siège social en la cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le seize mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 3940G-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.7221-42) Le Conseil des Oeuvres Extrait des règlements de la corporation ci-haut mentionnée, tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 3 décembre 1953, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à quinze: \"Conseil d'administration \u2014 Nombre des directeurs.1.Les affaires de la.corporation sont administrées par un Conseil d'Administration composé de quinze directeurs choisis annuellement parmi les membres.\" Certifié conforme.Montréal, le 2 février 1955.Le Secrétaire, 39470-o (Signé) J.-C.BEAUDIN, ptre.(P.G.7221-42) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la Province a approuvé, le dix-sept mars 1955, les règlements de \"Le Conseil des Oeuvres\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le dix-sept mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39470-o JEAN BRUCHESI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de L'Assomption, Beauce\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le seize mars 1955.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé a Saint-Georges-Est, comté de Beauce.Le Sous-secrétaire de la Province.39471-0 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.11537-54) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the by-laws of \"Pointe Claire Civic Action League\" were approved by the Honourable the Provincial Secretary on January 24th, 1955, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th dav of January, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39403-o Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 102, as added by Act II George VI, chapter 52, section 5, the Honourable the Provincial Secretary has enacted on March eleventh, 1955, the termination of the corporate existence of \"L'Association des Poseurs de Lattes Métalliques de Montréal\", whose incorporation into a professional syndicate has been authorized on April 3rd, 1930, with its head office in the city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, on March sixteenth, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39400 Under Secretary of the Province.(A.G.7221-42) Le Conseil des Oeuvres Excerpt of by-laws of the above mentioned corporation, as adopted at the meeting held on December 3rd, 1953, concerning the increase in the number of Directors from three to fifteen: \"Board of Directors \u2014 Number of Directors.1.The affairs of the corporation are managed by a Board of Directors' composed of fifteen Directors chosen annually amongst its members.\" Certified true copy.Montreal, February 2nd, 1955.(Signed) J.-C.BEAUDIN, Priest, 39470 Secretary.(A.G.7221-42) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy, Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on March seventeenth, 1955, the by-laws of \"Le Conseil des Oeuvres\", and such pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this seventeenth dav of March, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39470 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de L'Assomption, Beauce\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on March sixteenth, 1955.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Georges-East, countv of Beauce.JEAN BRUCHÉSI, 39471 Under Secretary of the Province. 968 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 Chartes \u2014 Abandon de Les Immeubles Marquis Ltée Marquis Realties Ltd Avis est donné que Les Immeubles Marquis Ltée, compagnie constituée sous l'empire de la Loi des Compagnies de Québec, et qui a son siège social à Granby, demandera au Procureur Général la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des Compagnies de Québec.Daté à Granby, ce 8 mars 1955.Le Secrétaire, 39444-Q RACHEL BISSONNETTE.AVIS Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Plaza Realty Corpn.\" s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner, sa charte.Montréal, 17 février 1955.Le Procureur de Plaza Realty Corpn., 39449 HAROLD LANDE C.R.Waden Inc.En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Waden Inc.\", donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission «l'abandonner sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Daté à Bolton Ouest, P.Q., ce 29c jour de janvier 1955.Le Secrétaire, 39450 L.K.EDEN.Charters \u2014 Surrender of Les Im.mkublks Marquis Ltée Marquis Realties Ltd Notice is hereby given that Marquis Realties Ltd, a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Granby, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Granby, this 8th day of March 1955.RACHEL BISSONNETTE, 39444-0 Secretary.NOTICE Notice is hereby given under the provisions of the Quebec Companies' Act that \"Plaza Realty Corpn.\" will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter.Montreal, February 17th, 1955.HAROLD LANDE, Q.C., 39449-0 Solicitor for Plaza Realty Corpn.Waden Inc.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Waden Inc.\", hereby gives notice that this Company will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter and its cancellation from a, date to be fixed by them.Dated at West Bolton, P.Q., this 29th day of January, 1955.L.K.EDEN, 39450-o Secretary.Compagnie autorisée à faire Company Licensed to do des affaires Business (Sec.P.194-55) (P.Sec.194-55) Avis est, par les présentes, donné que la com- Notice is hereby given that \"Gosho Trading pagnie \"Gosho Trading Company, Inc.\", a été Company, Inc.\" has been licensed to carry on autorisée à exercer son commerce dans la pro- business in the Province of Quebec, pursuant to vince de Québec, conformément aux dispositions the provisions of the Extra-Provincial Compa- de la Loi des compagnies à fonds social étrange- nies' Act, R.S.Q.1941, chapter 279.res, S.R.Q.1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans The principal office of the said Company in la Province est à 395 rue Mayor, en les cité et the Province is 395 Mayor Street, in the city district judiciaire de Montréal.and judicial district of Montreal.Son agent principal, aux fins de recevoir les Its chief agent for the purpose of receiving assignations dans toutes procédures prises con- services in proceedings against it is Mr.Tos- tre elle, est M.Toshiharu Misu, de ladite cité hiharu Misu, of the said city of Montreal, de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Pro- Given at the office of the Provincial Secretary, vince, ce 17e jour dc mars 1955.this 17th day of March, 1955.Le Sous-secrétaire dc la Province, JEAN BRUCHÉSI, 39437 JEAN BRUCHÉSI, 39437-o ' Assistant Provincial Secretary.Département de l'Instruction Publique Department of Educatiou N° 120-54.No.120-54.Québec, le 5 mars 1955.Quebec, March 5th, 1955.Demande est faite que le territoire actuel dc la Application is made to have the present municipalité scolaire de ville St-Joseph-de- territory of the school municipality of the town QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 969 Grantham, dans le comté de Drummond, soit .annexé pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de la cité de Drummondville, dans le même comté.Le Surintendant dc l'Instruction publique, 39407-10-2-o 0.J.DÉSAULNIERS.N° 915-54.Québec, le 4 mars 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Jérôme N° 4, dans le comté des Deux-Montagnes, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire dc St-Antoine-dcs-Laurentidcs, dans le comté de Terrebonne.Ce territoire fait partie du cadastre officiel de la paroisse de St-Jérôme, dans le comté de Terre-bonne, et comprend les lots 1 à 9 inclusivement de la Côte St-Gcorges et 92, 93 à 101 inclusivement de la concession des Prairies.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39408-10-2-o 0.J.DÉSAULNIERS.N° 1335-54.Québec, le 12 mars 1955.Demande est faite d'ériger en municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles protestants de Pointe-aux-Trembles.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39459-11-2-0 0.J.DÉSAULNIERS.N° 121-55.Québec, le 11 mars 1955.' Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Bruno paroisse, comté de Chambly, un certain territoire comprenant une superficie de 1 arpent prise à même le lot N° 310 ainsi qu'une superficie dc 1 arpent prise à même le lot N° 309, tous du cadastre officiel de la paroisse dc St-Bruno pour l'annexer à la municipalité scolaire dc St-Basile-le-Grand, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39460-1 l-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 552-54.Québec, le 11 mars, 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 2 mars 1955, de détacher de la municipalité scolaire de Lacolle, dans le comté de St-Jean, le lot N° 1 du cadastre officiel de la paroisse de St-Valentin et la partie du lot 420 du même cadastre, bornée au sud par la rivière Lacolle, à l'ouest par la ligne de division entre les lots 420 et 427, au nord par la ligne qui passe dans la Montée Bowman et à l'est par le chemin de fer Canadien National, pour les annexer à la municipalité scolaire dc St-PauI-de-lTle-aux-Noix, même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 39461-o O.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel du canton de Dalmas division d'enregistrement de Lac-St-Jean-Ouest.of St-Joscph-of-Grantham, in the county of Drummond, annexed for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of the city of Drummondville, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 39407-10-2 Superintendent of Education.No.915-54.Quebec, March 4th, 1955.Application is made to detach from the school municipality of St-Jérôme No.4, in the county of Two-Mountains, the territory hereinunder drescribed to annex it to the school municipality of St-Antoine-des-Laurentides, in the county of Terrebonne.This territory forms part of the official cadastre of the parish of St-Jérôme, in the county of Terrebonne, and is comprised of lots 1 to 9 inclusively of Côte St-Gcorges and 92, 93 to 101 inclusively of the des Prairies concession.O.J.DÉSAULNIERS, 39408-10-2 Superintendent of Education.No.1335-54.Quebec, March 12th, 1955.Application is made to erect into a separate school municipality for Protestants only, the territory presently under the jurisdiction of the Protestant School Trustees of Pointe-aux-Trem-bles.O.J.DÉSAULNIERS, 39459-11-2 Superintendent of Education.No.121-55.Quebec, March 11th, 1955.Application is made to detach from the school municipality of St.Bruno parish, county of Chambly, a certain territory comprising an area of 1 arpent taken from lot No.310 as well as an area of 1 arpent taken from lot No.309, all of the official cadastre of the parish of St.Bruno, in order that it be annexed to the school municipality of St.Basile-le-Grand, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 39400-11-2 Superintendent of Education.No.552-54.Quebec, March 11th, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council dated March 2nd, 1955, to detach from the school municipality of Lacolle, in the comity of St.John, lot No.1 of the official cadastre of the parish of of St.Valentin and that part of lot 426 of the same cadastre, bounded southerly by the Lacolle River, westerly by the dividing line between lots 426 and 427, northerly by the line passing along Montée Bowman and easterly by the Canadian National Railroad, in order to annex them to the School Municipality of St.Paul-de-l'Ile-aux-Noix, same county.This Order in Council shall take effect on July 1st, 1955.^ O.J.DÉSAULNIERS, 39461 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the township of Dalmas registration division of Lake St.John West. 970 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 Avis est par la présente donné que les îles Nos 133 à 185 de la Rivière Grande Péribonka, sont ajoutées en vertu, de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 A VILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Gamier division d'enregistrement de Lac-St-Jean-Est.Avis est par la présente donné que les îles Nos 1 à 50 de la Rivière Grande Péribonka ont été annulées et les îles Nos 53 à 93 sont ajoutées en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 février 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la cité de Hull, quartier N° 2 division d'enregistrement de Hull.Avis est par la présente donné que les lots 175-8, 155-3, 300, 204-2, 155-4, 175-9, 400, 154-1, 404, 204-8, 155-5, 154-2, 153-1, 204-9, 153-3, 425, 153-2, 154-3, 137-3, 138-3, 153-4 et partie des lots 402, 403, 138-4 sont annulés, les lots 397, 398, 399, 401 et 402 sont corrigés et le lot 427 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.Notice is hereby given that Island Nos 133 to 185 of Grande Péribonka River are added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, March the 7th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the township of Gamier registration division of Lake St.John East.Notice is hereby given that Islands 1 to 50 of Grande Péribonka River are cancelled and Islands 53 to 93 are added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 20th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the city of Hull, ward No.2 registration division of Hull.Notice is hereby given that lots 175-8, 155-3, 300, 204-2, 155-4, 175-9.400, 154-1, 404, 204-8, 155-5, 154-2, 153-1, 204-9, 153-3, 425, 153-2, 154-3, 137-3, 138-3, 153-4 and part of lots 402, 403, 138-4 are cancelled; lots 397, 398, 399, 401 and 402 arc corrected and lot 427 has been added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, March 7th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD.39439»o Deputy Minister.AVIS Cadastre officiel de la municipalité du village de Montmagny division d'enregistrement de Montmagny.Avis est par la présente donné que les lots 203-4, 193 partie des lots 203, 211, 212, une partie de ruelle sont annulés, le lot 194 est corrigé et les lots 294 à 298 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code vivil.Québec, le 7 février 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse-de-BIainviIIe (paroisse de Roscmère) division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné aue les lots 54-4, 54-5, 56-5, 50-11, 57-4 à 57-7, 57-9 à 57-13, 57-24 à 57-37 sont annulé en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 31 janvier 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the municipality of the village of Montmagny registration division of Montmagny.Notice is hereby given that lots 203-4, 193, part of lots 203.211, 212 part of a lane arc cancelled, lot 194 is corrected and lots 294 to 298 are added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 7th, 1955.N Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of Ste.Thérèse-de-Blainville (parish of Rosemère) registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lots 54-4, 54-5, 56-5, 56-11, 57-4 to 57-7, 57-9 to 57-13, 57-24 to 57-37 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 31st, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol 87, No.11 971 AVIS Cadustre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville (maintenant partie de la paroisse de Rosemèrc) division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que le lot 30-33 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 4 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Hilaire (Village de St-Hilaire) division d'enregistrement dc Rouville.Avis est par la présente donné que les lots 100-135, 100-130, 100-150, 100-157, 100-177 102-1 à 102-32, 103-1 à 103-57 et partie des lots 100-140 et 100-107 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 4 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Sennevillc division d'enregistrement dc l'Abitibi.Avis est par la présente donné que les lots 11 à 13, MA, 14B, 15 du Rang III, 15 du Rang IV, 10 du Rang V sont corrigés, le Bloc B est ajouté, les lots 15 à 21 du Rang B sont corrigés et le Bloc C est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le-2S février 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel revisé d'une partie de la paroisse de St-Jérômc-de-Matane, comprise dans les limites de la ville de Matane division d'enregistrement de Matane.Avis est par la présente donné (pie le lot 08-2 est corrigé et le lot 08-33 est ajouté en vertu de l'article 2174A du ('ode civil.Québec, le 9 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton dc Turcotte division d'enregistrement dc La Tuque.Avis est par la présente donné que le lot 75 est annulé et les lots 1 à 09 du Rang D sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 mars 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 39439-0 AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Ste.Thérèse-de-BIainville (Now part of the parish of Rose-mère) registration division of Terrebonne.¦* Notice is hereby given that lot 30-33 is cancelled in virtue of Article 217-1A of the civil Code.Quebec, March the 4th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of St.Hilaire (village of St.Hilaire) registration division' of Rouville.Notice is herebv given that lots 100-135.100-136, 100-150, 100-157, 100-177, 102-1 to 102-32, 103-1 to 103-57 and part of lots 100-140 and 100-107 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, March 4th, 1955.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the township of Sennevillc registration division of Abitibi.Notice is hereby given that lots 11 to 13, 14A, 14B, 15 of Range III, 15 of Range IV, 10 of Range V are corrected, Block B is added, lots 15 to 21 of Range B are corrected and Block C is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 28th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official revised cadastre of part of the parish of St.Jérôme-de-Matane, comprised into the limits of the town of Matane registration division of Matane.Notice is hereby given that lot 08-2 is corrected and lot 08-33 is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, March the 9th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the township of Turcotte registration division of La Tuque.Notice is hereby given that lot 75 is cancelled and lots 1 to 09 of Range D are added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, March the 10th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 39439-0 Deputy Minister. 972 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses des Trois-llivièrcs et district lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes au décret numéro 1040 du 4 août 1948 et amendements, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la région des Trois-Rivières.1° Dans la Section \"A\", les item \"Barbe, Coupe de cheveux pour adultes, Coupe de cheveux en brosse pour adultes, Coupe de cheveux pour enfants dc moins dc 15 ans, Coupe de cheveux en brosse pour enfants\" apparaissant à l'article IV dans l'échelle de prix des services pour la zone III, seront remplacés par les sui- vants: \"Barbe, tous les jours.$0.50 Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.05 Vendredi, samedi et veille des fêtes chômées et les 3 jours précédant Noël, le Premier dc l'An et Pâques.0.75 Coupe de cheveux en brosse pour adultes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.85 Vendredi, samedi et veille des fêtes chômées .1.00 Coupe de cheveux pour enfants de moins de 15 ans: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.50 Vendredi, samedi et veille des fêtes chômées .0.00 Coupe de cheveux en brosse pour enfants: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.50 Vendredi, samedi et veille des fêtes chômées.0.70\" 2° Le dernier alinéa du paragraphe \"a\" de l'article V, Section \"A\", commençant par les mots \"Cependant, dans la ville de Louiseville\" sera remplacé par le suivant: \"Cependant, dans la zone III, la coupe de cheveux est permise toute la journée du lundi au Collège de Louiseville, à l'Hospice de Louise-ville et à l'Hôpital.\" 3° L'alinéa suivant sera ajouté à l'article VII, Section \"A\", pour en devenir le quatrième alinéa: \"A Louiseville, les vacances doivent être prises la première^semaine du mois d'août de chaque année.\" Durant les trente jours à compter dc la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail\" recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Soûs-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 mars 1955.39438-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de Ja Loi de la conven- Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 103 and amendments), that the Parity Committee of Barbers, Male and Female Hairdressers of the district of Trois-Rivières, has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the decree number 1010 of August 4th, 1948 and amendments, relating to the harboring and bail-dressing trades in the district of Trois-Rivières.1.In part \"A\", the following items: \"Shave, Haircut for adults, Brushcut for adults, Haircut for children under 15 years of age, Brushcut for children\" appearing in section IV, in the tabic of prices for zone III, will be replaced by the following: \"Shave (every day).80.50 Haircut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.05 Friday, Saturday and holiday eves and the three days preceding Christmas, New Year's Day and Easter Sunday.0.75 Brushcut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.85 Friday, Saturday and holiday eves.1.00 Haircut for children under 15 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and \"Thursday.0.50 Friday, Saturday and holiday eves.0.00 Brushcut for children: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.50 Friday, Saturday and holiday eves.0.70\" 2.The last paragraph of subsection \"a\" of section V, Part \"A\", beginning with the works \"However, in the town of Louiseville\" will be replaced by the following: \"However, in zone III, it shall be permissible to cut the hair all day Monday at the College of Louiseville, at the \"Hospice\" of Louiseville and at the Hospital.\" 3.The following paragraph will be added to section VII, Part \"A\", to become the fourth paragraph thereof: \"In Louiseville, vacations shall be taken each year in the first week of August.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 19th, 1955.39438-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the collective Agreement Act QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 973 tion collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du comté de Stanstead lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 254 du 5 mars 1953, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la ville de M agog et un rayon dc huit (S) milles de ses limites: Au paragraphe \"a\" de l'article VII, les prix minima ci-après mentionnés seront substitués à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour chacun des services concernés: \"Coupe dc cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.80.65 Vendredi, samedi et veilles des fêtes chômées ainsi que les 2 jours précédant Noël et le Premier de l'An____ 0.75 Coupe de cheveux pour enfants: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.50 Vendredi, samedi et veille des fêtes chômées.0.75\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 mars 1955.39438-0 AVIS L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions dc la Loi de la Convention Collective (S.R.Q.1941, chap.163 et amendements), qu'une requête lui a été soumise par les parties contractantes ci-après mentionnées, dans le but dc rendre obligatoire la convention de travail intervenue entre: D'une Part, La Coopération des Propriétaires de Laboratoires Dentaires, Et d'autre part.L'Union Fédérale des Techniciens-Dentaires du C.M.T.C., Local 610, pour les employeurs et les employés de l'industrie et des métiers et occupations concernés, d'après les conditions suivantes: I.Juridiction industrielle: Le décret s'appliquera: a) à tous les propriétaires de laboratoires dentaires; b) à tous les employés engagés comme techniciens dentaires; c) à tous les employés engagés comme apprentis techniciens dentaires; Pour les fins du décret, un artisan sera celui qui possède son propre laboratoire dentaire, accomplit un travail manuel dans ce même laboratoire et est couvert par le décret.IL Juridiction territoriale: La juridiction territoriale pour l'application du décret comprendra la Province de Québec en son entier et, pour fins d'application, sera divisée en deux zones décrites comme suit :.Zone 1: L'île de Montréal et un rayon de trente (30) milles autour de ses limites; Zone 2: Toute la Province de Québec, à l'exception du territoire mentionné dans la Zone 1.(R.S.Q.1941, chapter 103 and amendments), that the Barbers and Hairdressers Parity Committee for the County of Stanstead has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree No.254 of March 5th, 1953, relating to the barbering and hair-dressing trades in the town of Magog and a radius of eight (8) miles from its limits: In subsection \"a\" of section VII, the minimum prices hereafter mentioned will, be substituted for those actually mentioned in the decree for each one of the services concerned: \"Haircut for adults: t Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.80.05 Friday, Saturday and^ holiday eves, including the two days preceding Christmas and New Year's Day.0.75 Haircut for children: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.50 Friday, Saturday, and holiday eves.0.75\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Quebec, March 19th, 1955.39438-o NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chap.163 and amendments), that a petition has been submitted to him by the contracting parties hereinafter mentioned for the purpose of rendering obligatory the collective labour agreement entered into between : On the one part, La Cooperation des Propriétaires de Laboratoires Dentaires, And on the other part, L'Union Fédérale des Techniciens-Dentaires du C.M.T.C.Local 610, for the employers and employees of the industry and the trades and occupations concerned, according to the following conditions: I.Industrial jurisdiction: The decree shall apply: a) to all owners of dental technician laboratories; b) to all employees engaged as dental technicians; c) to all employees engaged as apprentice dental technicians; For the purpose of this decree, an artisan shall be considered as one who owns his own dental technician laboratory and performs manual work therein and is covered by the decree.II.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction, for the application of the decree, shall comprise the entire Province of Quebec and, for the purpose of its application, shall be divided into two zones as follows: Zone 1: The Island of Montreal and a radius of thirty (30) miles around its limits; Zone 2: The entire Province of Quebec with the exception of the territory mentioned in Zone 1. 974 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 III.Heures de travail: Les heures de travail pour les employés de ladite industrie seront fixées comme suit: Huit (8) heures par jour réparties entre 8.30 a.m.et 5.30 p.m.Tout travail accompli après 5.30 p.m.sera rémunéré au taux de salaire et demi basé sur le taux horaire ou le taux à la pièce.Une période d'une heure pour le lunch sera établie.Salaire double basé sur les taux horaires ou à la pièce sera payé pour tout travail accompli le samedi ou le dimanche.IV.Taux de salaires: Les taux minima suivants s'appliqueront : Lorsque les personnes visées par ce décret seront rémunérés sur une base horaire, le taux sera: Taux horaires Zones 1 2 ' Techniciens dentaires.SI .75 $1.65 Lorsque les personnes visées par ce décret seront rémunérées sur une base de travail à la pièce, les taux pour les Zones 1 et 2 seront observés comme minimum, tout en permettant une rémunération plus élevée dans la production de travail à la pièce, comme encouragement.Les apprentis seront rémunérés sur une base horaire, comme suit, dans les Zones 1 et 2: Taux horaires 1ère année.$0.50 2ième année.'.0.05 3ième année.0.80 4ième année.1.00 5ième année.1.25 Le Comité paritaire aura le droit, en tout temps, de demander et d'obtenir des propriétaires de laboratoires dentaires, toutes les informations concernant leur production pour les besoins généraux de l'administration de ce décret, et plus particulièrement, afin de déterminer la relation entre les taux du travail à la pièce et les taux minima horaires.V.Congés statutaires: Compensation pour jours de congé.\u2014 Un employeur qui ferme complètement son laboratoire afin d'observer les congés ci-après énumérés, devra accorder à chaque employé le salaire d'une pleine journée, basé sur huit (8) heures de travail aux taux minima mentionnés plus haut.Le Jour de l'An, Vendredi-Saint, Ascension, Fête de la Reine Victoria, St-Jean-Baptiste, Confédération, Fête du Travail, Action de Grâces et Noël sont désignés ci-après comme jours de congé pour les fins du décret.Tout travail accompli pendant les jours de congés mentionnés plus haut sera rémunéré au taux de salaire double basé sur les taux horaires minima réguliers mentionnés plus haut.VI.Vacances payées: Toutes les personnes assujetties au décret auront droit à une semaine de vacances payés après une année de service.Cette rémunération sera égale à 2% du salaire reçu pendant l'année.De plus, une deuxième semaine de vacances payée sera accordée à tous les techniciens dentaires laquelle sera aussi rémunérée à raison de 2% du salaire reçu pendant l'année.VIL Comité paritaire: Un Comité paritaire sera formé pour administrer le décret dans la juridiction territoriale déterminée dans la présente requête et sera investi de tous les droits, prérogatives et responsabilités prévus dans la Loi.VIII.Durée du décret.Le décret entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette III.Hours of labour.; The hours of labour for employees of the said industry shall be fixed as follows: Eight (8) hours per day, between 8.30 a.m.and 5.30 p.m.All work performed after 5.30 p.m.shall be remunerated at time and one half the hourly rate or the piece-work rate.A lunch period of one hour's duration shall be established.Double time based on the hourly or piecework rates herein shall be paid for all work performed on Saturday or Sunday.IV.Wage rates: The following minimum wages shall apply: Where persons covered herein are remunerated on an hourly basis, the rate shall be: Per hour Zones 1 2 Dental technicians.$1.75 $1.05 Where persons covered are remunerated on a niece-work basis, the rates for Zones 1 and 2 snail be observed as a minimum, while permitting greater remuneration through piece-work production as an inventive.Apprentices shall be remunerated on an hourly basis, as follows, in both Zones 1 and 2: Per hour 1st y ear.$0.50 2nd year.0.05 3rd year.0.80 4th year.1.00 5th year.1.25 The Parity Committee shall be entitled, at any time, to request and obtain from dental technician laboratory owners, full information as to their production for the general purposes of administering this decree, and more particularly in order to determine the relationship between piece-work rates and hourly rate minimums.V.Holidays: Compensation for holidays.\u2014 An employer who completely closes his laboratory in order to observe the holidays hereinafter enumerated, shall grant each employee a full day's wages based on 8 hours' pay at the minimum rates mentioned herein.New Year's Day, Good Friday, Ascension Day, Victoria Day, St.John the Baptist Day, Canada Day, Labour Day, Thansgiving Day and Christmas Day, are hereby designated as holidays for the purpose of the decree.All work performed on the above mentioned holidays shall be remunerated at the rate of double time the regular minimum hourly rates mentioned herein.VI.Vacations with pay: All persons governed by the decree shall be entitled to one week's vacation with pay after one year's service.The vacation pay shall be equal to 2% of the annual earnings.Also, a second week's vacation with pay shall be given to all dental technicians with another 2% of the annual earnings.VII.Parity Committee: A Parity Committee shall be formed to administer the decree in the territorial-jurisdiction determined in the present petition and shall be vested with all the rights, prerogatives and liabilities under the Act.VIII.Duration of the decree.The decree will come into force on the date of its publication in QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 975 officielle de Québec et.demeurera en vigueur pendant un an à compter de cette date.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections (pie les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 mars 1955.39438-0 the Quebec Official Gazette and will remain in force for one year from that date.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 19th, 1955.39438-0 Ministère des Finances Assurances Avis d'émission de permis ET DE CERTIFICAT d'eNKEOISTREMENT Avis est donné, par les présentes, que \"Affiliated F M Insurance Company\", enregistrée sous le numéro 556, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1896 qui l'autorise, à compter du 28 décembre 1954, à effectuer\"dans la Province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie et accessoirement \u2014 agitation civile, défectuosité d'extincteurs automatiques, choc de véhicules, chute d'aéronef, explosion limitée ou inhérente, fuite d'eau, grêle, intempéries, ouragan, tremblement de terre; Transport intérieur; Vol; Et en outre de ces genres: Navigation intérieure et océanique.Le siège social de la compagnie est situé à Providence, état du Rhode Island, États-Unis d'Amérique.La compagnie a nommé monsieur Thomas R.Durley, 3720, avenue Van Home, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 5 mars 1955.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 39396-10-2-o Surintendant des assurances.Department of Finance Insurance Notice of issue of license and certificate of registration Notice is hereby given that \"Affiliated F M Insurance Company\", registered under number 556, has obtained the license and certificate of registry number 1896 authorizing it, as from the 28th of December 1954, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Fire, and supplementary thereto \u2014 civil commotion, earthquake, falling aircraft, hail, impact by vehicles, limited or inherent explosion, sprinkler leakage, water damage, weather, windstorm; Inland transportation; Theft; And in addition to these classes: Inland and ocean marine.The head office of the company is situate at Providence, State of Rhode Island, United States of America.The company has appointed Mr.Thomas R.Durley, 3720 Van Home Avenue, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 5th of March 1955.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 39396-10-2-o Superintendent of Insurance.Sièges sociaux Avis est donné que la Compagnie \"Agences d'Assurance Sept-Iles Ltée\" constituée en corporation par lettres patentes du 11 décembre 1954-et ayant son bureau-chef dans la cité de Sept-Iles, a établi son bureau au numéro 500 Avenue Brochu, Sept-Iles.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme son bureau principal.Donné à Sept-Iles ce 5ième jour de mars 1955.(Sceau) Le Secrétaire, 39445-0 MME CHARLES MORIN.AVIS Veuillez prendre avis qu'en vertu des lettres patentes supplémentaires obtenues le 3 février 1955, le nom de la compagnie Gobeil Lumber Ltée a été changé en Forêt-Québec Ltée et que le bureau chef de cette compagnie est à 130 St-.Iean, Québec.Forêt-Québec Ltée Par le Secrétaire, 39458-0 S.GOBEIL.Head Offices Notice is hereby given that \"Agences D'Assurance Sept-Iles Ltée, incorporated by letters patent dated December 11th, 1954, and having its head office, in the city of Sept-Iles, has established its office at 500 Avenue Brochu, Sept-Iles.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Sept-Iles, this 5th day of March 1955.(Seal) MME CHARLES MORIN, 39445-o Secretary.NOTICE Notice is hereby given that according to supplementary letters patent obtained on February 3rd, 1955, the name of the company Gobeil Lumber Ltée has been changed into Forêt-Québec Ltée and that head office of this company is at 130 St-John Street, Quebec.Forêt-Québec Ltée by S.GOBEIL, 39458 Secretary. 970 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 Avis est donné que la Compagnie \"Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited\", constituée en corporation par lettres patentes du 9 février 1955 et ayant son bureau-chef dans la cité de Québec, a établi son bureau au numéro 80, rue Sl-Picrrc, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme son bureau principal.Donné à Québec, ce 10 mars 1955.Les Procureurs de la Compagnie, PRÉVOST, GAGNÉ, 39440-O FLYNN & CHOUINARD.Copper Cuff Consolidated Mining Corporation (No Personal Liability) Avis dc changement du siège social La compagnie \"Copper Cliff Consolidated Mining Corporation\", No Personal Liability, constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la Loi des compagnies minières dc Québec,.le 11 octobre 1952, et ayant son siège social en la cité de Montréal, à 215 ouest, rue St-J.acques, l'a transporté à suite 1209, 507 Place d'Armes, Montréal, Québec.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 10e jour de mars 1955.Le Président, 39451 JOHN C.UDD.AVIS Veuillez prendre avis que \"Annuaire Marcotte Ltée\", incorporé par lettres patentes en date du 3 février 1955, a établi son bureau-chef à 130, rue St-Jean, Québec.Annuaire Marcotte Limitée Par le Secrétaire, 39457-0 LUC FAILLE.Notice is hereby given that \"Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited\", incorporated by letters patent dated February 9th, 1955, and having its head office, in the city of Quebec, has established its office at 80 St.Peter Street, Quebec City.From and after the date of this notice the said office shall be considered by Company as being the head office of the company.Dated at Quebec, this 10th day of March 1955.PRÉVOST, GAGNÉ, FLYNN & CHOUINARD, 39440-o Attorneys for the Company.Copper Cliff Consolidated Mining Corporation (No Personal Liability) Notice of change of head office \"Copper Cliff Consolidated Mining Corporation\", No Personal Liability, incorporated by letters patent issued under the Quebec Mining Companies' Act dated 11th October, 1952 and having its head office in the city of Montreal at 215 St.James Street, West, has moved it to Suite 1209, 507 Place d'Armes, Montreal, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 10th day of March, 1955.JOHN C.UDD, 39451-0 President.NOTICE Notice is hereby given that \"Annuaire Marcotte Ltée\", incorporated by letters patent dated February 3rd, 1955, has established its head office at 130 St-John Street, Quebec.Annuaire Marcotte Limitée by LUC FAILLE, 39457 Secretary.Soumissions Province de Québec Ville de Richmond (Comté de Richmond) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, G.Marveau Alexander, secrétaire-trésorier, P.P.700, Hôtel de Ville, Richmond, comté dc Richmond, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 4 avril 1955 pour l'achat de $134,000.00 d'obligations de la ville de Richmond, comté de Richmond, datées du 1er avril 1955 et remboursables par séries du 1er avril 1956 au 1er avril 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4^% par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 248 \u2014$69,000 \u2014 construction d'une annexe à une bâtisse municipale, aqueduc et égouts, etc.; et règl.N° 249 \u2014 $05,000 \u2014 construction d'une bâtisse municipale, aqueduc et égouts.Tenders è Province of Quebec Town of Richmond (CoUnty of Richmond) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned G.Marveau Alexander, Secretary-Treasurer, P.O.Box 700, Town Hall, Richmond, county of Richmond, until 8 o'clock p.m., Monday, April 4th, 1955, for the purchase of an issue of $134,000.00 of bonds of the Town of Richmond, county of Richmond, dated April 1st, 1955 and redeemable serially from April 1st, 1950, to April 1st, 1975 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4^% per annum, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-law No.248 \u2014 $69,000 \u2014 construction of an addition to a municipally owned building, waterworks and sewers, etc.; and By-law No.249 \u2014 $65,000 \u2014 construction of a municipal building, waterworks and sewers. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 977 Pour fins d'adjudication seulement, le calcul Only for the purposes of awarding the issue, d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.computation of interest will be made as from May 1st, 1955.Le Tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement\u20148134,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1956.$4,000.00 1er avril 1957.4,000.00 1er avril 1958.4,000.00 1er avril 1959.4,500.00 1er avril 1960.5,000.00 .1er avril 1961.5,000.00 1er avril 1902.5,000.00 1er avril 1963.5,500.00 1er avril 1964.0,000.00 1er avril 1905.0,000.00 1er avril 1966.0,500.00 1er avril 1907.7,000.00 1er avril 1908.7,000.00 1er avril 1909.7,500.00 1er avril 1970.8,000.00 1er avril 1971.8,500.00 1er avril 1972.9,500.00 1er avril 1973.10,000.00 1er avril 1974.10,000.00 1er avril 1975.11,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Richmond, comté de Richmond.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Richmond, comté de Richmond.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec.1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il alfectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 4 avril 1955, à 8 heures p.m., en l'Hôtel de Ville, Richmond, comté de Richmond.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Richmond, (Comté de Richmond), ce 15 mars 1955.Le Secrétaire-trésorier, G.MARVEAU ALEXANDER.B.P.700, Hôtel de Ville, Richmond.(Comté de Richmond), P.Q.39467-o Table of rédemption Year April 1st, 1956.April 1st, 1957.April 1st, 1958.April 1st, 1959.April 1st, 1960.April 1st, 1901.April 1st, 1962., April 1st, 1963.April 1st, 1964.April 1st, 1965.April 1st, 1966.April 1st, 1967.April 1st, 1968.April 1st, 1969.April 1st, 1970.April 1st, 1971.April 1st, 1972.April 1st, 1973.April 1st, 1974.April 1st, 1975.8134,000.00 \u2014 20 years Capital .84,000.00 .4,000.00 .4,000\".00 .4,500.00 .5,000.00 .5,000.00 .5,000.00 .5,500.00 .G.000.00 .0,000.00 .0,500.00 .7,000.00 .7,000.00 .7,500.00 .8,000.00 .8,500.00 .9,500.00 .10,000.00 .10,000.00 .11,000.00 The successfid tenderer agrees to pay for the 'bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Richmond, county of Richmond.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or Richmond, county of Richmond.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be' called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, April 4th, 1955, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall, Richmond, county of Richmond.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Richmond, (County of Richmond), this 15th of March, 1955.G.MARVEAU ALEXANDER, Secretary-Treasurer.P.O.Box 700, Town Hall, Richmond, (County of Richmond), P.Q.39407-o Province de Québec Province of Quebec Les commissaires d'écoles pour la mu.nici- School commissioners for the municipality palité DE la cité DE LaCHINE of THE city of LaCHINE (Comté de Jacques-Cartier) (County of Jacques-Cartier) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront, reçues par le soussigné, A.Saint-Denis, secrétaire-trésorier, 110, 15ème Avenue, Lachine, comté de Jacques-Cartier, jusqu'à 8.30 heures p.m., mardi, le 5 avril 1955, pour l'achat de $690,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Lachine, comté de Jacques-Cartier, datées du 1er avril 1955 et remhour- Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned A.Saint-Denis, secretary-treasurer, 110, 15th Avenue, Lachine, county of Jacques-Cartier, until 8.30 o'clock p.m., Tuesdav, April 5th, 1955, for the purchase of an issue of $090,000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of the city of Lachine, county of Jacques-Cartier, dated April 1st, 1955 and redeemable serially from 978 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 sables par séries du 1er avril 1956 au 1er avril 1975 inclusivement; avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni suférieur à 4%% par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission où il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 10 août 1954 \u2014 8360,000.00 \u2014 construction de l'école Jardin des Saints-Anges; et résolution d'emprunt en date du 27 janvier 1955 \u2014 8330,000.00 \u2014 construction d'une école de douze classes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $690,000.00 \u2014 20 ans Aimée 1er avril 1950.1er avril 1957.\tCapital\t x\t851,000\t00 x\t53,500\t00 x\t50,000\t00 x\t58,500\t00 x\t01,000\t00 x\t33,500\t00 x\t34,500\t00 x\t36,500\t00 \t20,000\t00 \t21,000\t00 \t22,000\t00 \t22,500\t00 \t23,500\t00 \t24,500\t00 \t25,500\t00 \t26,500\t00 \t28,000\t00 \t29,500\t00 \t30,500\t00 \t32,000\t00 1er avril 1904.1er avril 1965.1er avril 1966.1er avril 1967.1er avril 1968.1er avril 1969.1er avril 1970.1er avril 1971.1er avril 1972.1er avril 1973.1er avril 1974.1er avril 1975.Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de S298,740.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en huit versements dont cinq de 848,682.50 et trois de 818,442.50, de 1950 à 1903 inclusivement, seront reçus et appliqués au service dc cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Lachine, comté de Jacques-Cartier.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec, à Lachine ou à Toronto.Lcsditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission-devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 5 avril 1955, «à 8.30 heures p.m., au bureau de la commission scolaire, 110, 15ème Avenue, Lachine, comté de Jacques-Cartier.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.April 1st, 1950 to April 1st, 1975 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 43^% per annum, payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated August 10th, 1954 \u2014 8300,000.00 \u2014 erection of the \"Jardin des Saints-Anges\" school; and loan resolution dated January 27th, 1955 \u2014 8330,000.00 \u2014erection of a school of twelve classrooms.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from May 1st, 1955.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 §690,000.00 \u2014 20 years Year Capital April 1st, 1956.x 851,000.00 April 1st, 1957.x 53,500.00 April 1st, 1958.x 56,000.00 April 1st, 1959.x 58,500.00 April 1st, 1960.x 61,000.00 April 1st, 1961.x 33,500.00 April 1st, 1902.x 34,500.00 April 1st, 1963.x 36,500.00 April 1st, 1964.20,000.00 April 1st, 1905.21,000.00 April 1st, 1966.22,000.00 April 1st, 1967.22,500.00 April 1st, 1968.23,500.00 April 1st, 1969.24,500.00 April 1st, 1970.25,500.00 April 1st, 1971.26,500.00 April 1st, 1972.28,000.00 April 1st, 1973.:.29,500.00 April 1st, 1974.30,500.00 April 1st, 1975.32,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of 8298,740.00 granted by the Provincial Secretary' and payable in eight instalments five, of which are of $48,682.50 and three of which are of $18,442.50, from 1956 to 1963 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Lachine, county of Jacques-Cartier.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal.Quebec.Lachine or at Toronto.The said bonds arc, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941.subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Tuesday, April 5th, 1955, at 8.30 o'clock p.m., at the office of the school commission, 110, 15th Avenue, Lachine, county of Jacques-Cartier.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 979 Lachine (comté de Jacques-Cartier), ce 17 Lachine (county of Jacques-Cartier), this mars 1955.» 17th day of March, 1955.Le Secrétaire-trésorier, A.SAINT-DENIS, A.SAINT-DENIS.Secretary-Treasurer.110, 15ème Avenue, Lachine, 110, 15th Avenue, Lachine, (Comté de Jacques-Cartier), P.Q.39473-0 (County of Jacques-Cartier), P.Q.39473 Province de Québec Province of Quebec Les commissaires d'écoles pour la munici- School commissioners for the municipality palité de la ville de BeAUCEVILLE-EsT of the tqwn of BeAUCEVILLE-EasT (Comté de Beauce) (County of Beauce) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Patrick Doyon, secrétaire-trésorier, C.P.32, Beauceville-Est, comté dc Beauce, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 4 avril 1955, pour l'achat de 840,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Beauceville-Est, comté de Beauce, datées du 1er avril 1955 et remboursables par séries du 1er avril 1956 au 1er avril 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4j^% par année payable semi-annucllcment les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 8 novembre 1954 \u2014 Solde de dépenses à effectuer re : école de garçons.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $40,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1956.$ 1,000.00 1er avril 1957.1,000.00 1er avril 1958.1,000.00 1er avril 1959.1,000.00 1er avril 1960.1,000.00 1er avril 1961.2,000.00 1er avril 1902.2,000.00 1er avril 1963.2,000.00 1er avril 1964.2,000.00 1er avril 1905.2,000.00 1er avril 1960.2,000.00 1er avril 1967.2,000.00 1er avril 1908.2,000.00 1er avril 1909.2,000.00 1er avril 1970.2,000.00 1er avril 1971.3,000.00 1er avril 1972.3,000.00 1er avril 1973.3,000.00 1er avril 1974.3,000.00 1er avril 1975.3,000.00 Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Patrick Doyon, secretary-treasurer, P.O.B.32, Beaucevilie-East, county of Beauce, until 8 o'clock p.m., Monday, April 4th, 1955, for the purchase of an issue of 840,000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of the town of Beauceville-East, county of Beauce, dated April 1st, 1955 and redeemable serially from April 1st, 1956 to April 1st, 1975 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4^% per annum, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated November Sth, 1954 \u2014 Balance of expenses in settlement re: Boys' School.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from May 1st, 1955.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $40,000.00 \u2014 20 years Year Capital April 1st, 1956.$ 1,000.00 April 1st, 1957.1,000.00 April 1st, 1958.1,000.00 April 1st, 1959.1,000.00 April 1st, 1960.1,000.00 April 1st, 1961.2,000.00 April 1st, 1902.2,000.00 April 1st, 1963.2,000.00 April 1st, 1964.2,000.00 April 1st, 1965.2,000.00 April 1st, 1966.2,000.00 April 1st, 1967.2,000.00 April 1st, 1968.2,000.00 April 1st, 1969.2,000.00 April 1st, 1970.2,000.00 April lot, 1971.3,000.00 April 1st, 1972.3,000.00 ' April 1st, 1973.3,000.00 April 1st, 1974.3,000.00 April 1st, 1975.3,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Beauceville-Est, comté de Beauce.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Beauceville-Est, comté de Beauce.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra dire accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Beauceville-East, county of Beauce.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Beauceville-East, county of Beauce.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the 980 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 l'emprunt et devra spécifier si le prix offert present issue and must specify whether interest comprend ou ne comprend pas les intérêts courus accrued on the bonds to the date of their delivery sur les obligations au moment de leur livraison, is included or not in the price of the tender.Les soumissions seront ouvertes et considérées The tenders will be opened and considered à une séance des commissaires d'écoles qui sera at a meeting of the school commissioners to be tenue lundi, le 4 avril 1955, à 8 heures p.m., en held on Monday, April 4th, 1955, at 8 o'clock l'école Monseigneur de Laval, Beauceville-Est, p.m., at the Monseigneur de Laval School, comté de Beauce.Beauceville-East, county of Beauce.Les commissaires d'écoles se réservent le droit The school commissioners do not bind them- de n'accepter ni la plus haute ni aucune des selves to accept the highest or any of the tenders, soumissions.Bcaucevillc-Est (comté de Beauce), ce 17 Beauceville-East (county of Beauce), March mars 1955.17th, 1955.Le Secrétaire-trésorier, PATRICK DOYON, PATRICK DOYON.Secretary-Treasurer.CP.32, Beauceville-Est, P.O.B.32,-Beauceville-East, (Comté de Beauce), P.Q.39472-o (County of Beauce), P.Q.39472 Province de Québec Pauoisse.de Saint-Romiald d'Etchemin (Comté de Levis) Province of Quebec Parish of Saint-Romuald d'Etchemin (County of Levis) Avis public est par les présentes donné que Public notice is hereby given that sealed des soumissions cachetées et endossées \"Soumis- tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be sions pour obligations\" seront reçues par le received by the undersigned A.Gosselin, secre- soussigné, A.Gossclin, secrétaire-trésorier, CP.7, tary-treasurer, P.O.B.7, Town Hall, 1247 Hôtel de Ville, 1247 rue Commerciale, Saint- Commercial Street, Saint-Romuald d'Etchemin Romuald d'Etchemin (Levis), jusqu'à 8 heures (Levis), until 8 o'clock p.m., Monday, April p.m., lundi, le 4 avril 1955, pour l'achat de 4th, 1955, for the purchase of an issue of 8050,- $050,000.00 d'obligations de la paroisse de 000.00 of bonds of the parish of Saint-Romuald Saint-Romuald d'Etchemin, comté de Levis, d'Etchemin, county of Levis, dated May 1st, datées du 1er mai 1955 et remboursables par 1955 and redeemable serially from May 1st, séries du 1er mai 1950 au 1er mai 1970 inclusi- 1956 to May 1st, 1970 inclusively, with interest vement, avec intérêt à un taux non inférieur à at a rate not less than 3% nor more than 43^% 3% ni supérieur à 4}/£% par année payable per annum, payable semi-annually on May 1st semi-annuellcment les 1er mai et 1er novembre and November 1st of each year.The rate of de chaque année.Le taux d'intérêt peut être interest may be the same for the whole issue or le même pour toute l'émission ou il peut varier it may vary according to fhaturities.suivant les échéances.Règlement d'emprunt numéro 118 \u2014 Cons- Loan by-law number 118 \u2014 Erection of a truction d'une usine de pompage et de filtration, pumping and filtering factory, reservoir, water- réservoir, aqueduc et égouts, etc.works and sewers, etc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul For purposes of adjudication only, interest d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.shall be calculated as from May 1st, 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $(150,000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1er mai 1956.$ 6,000.00 1er mai 1957.6,500.00 1er mai 1958.6,500.00 1er mai 1959.7,000.00 1er mai 1900.7,000.00 1er mai 1961.7.500.00 1er mai 1962.8,000.00 1er mai 1903.8,500.00 1er mai 1964 .8,500.00 1er mai 1965.9,000.00 1er mai 1966.9,500.00 1er mai 1967.10,000.00 1er mai 1968.10,500.00 1er mai 1969.10,500.00 1er mai 1970.535,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Romuald d'Etchemin, comté dc Lévis.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales d'une banque à charte dans la province de Québec.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera Table of redemption \u2014 $050,000.00 \u201415 years Year Capital May 1st, 1956.$ 6,000.00 May 1st, 1957.0,500.00 May 1st, 1958.6,500.00 May 1st, 1959.7,000.00 May 1st, 1960.7,000.00 May 1st, 1901 .7,500.00 May 1st, 1902.8,000.00 May 1st, 1963.8,500.00 May 1st, 1904.8,500.00 May 1st, 1905.9,000.00 May 1st, 1966.9,500.00 May 1st, 1967.10,000.00 May 1st, 1968.10,500.00 May 1st, 1969.10,500.00 May 1st, 1970.535,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Saint-Romuald d'Etchemin, county of Levis.Capital and interest are payable at all branches of a chartered bank in the Province of Quebec.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 981 es échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 4 avril 1955, à 8 heures p.m., en l'Hôtel de Ville, 1247 rue Commerciale, Saint-Romuald d'Etchemin, comté de Levis.Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Romuald d'Etchemin (comté de Lévis), ce 17 mars 1955.Le Secrétaire-trésorier, A.GOSSELIN.Hôtel de Ville, CP.7, 1247 rue Commerciale, Saint-Romuald d'Etchemin, (Comté de Lévis), P.Q.39474-o to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, April 4th, 1955, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall, 1247 Commercial Street, Saint-Romuald d'Etchemin, county of Levis.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Romuald d'Etchemin (county of Levis), this March 17th, 1955.A.GOSSELIN, Secretarv-Treasurer.Town Hall.P.O.B.7, 1247 Commercial Street, Saint-Romuald d'Etchemin.(County of Levis), P.Q.39474 Ventes d'effets non réclamés AVIS DE VENTE Avis est, par les présentes donné que tous les effets reçus avant le cinquième jour de mai 1954 et non réclamés aux bureaux de la \"Canadian Pacific Express Company\", à divers endroits des provinces du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Waddington, encanteur à 128 rue King est, Toronto, Ont., à onze heures du matin, le cinquième jour de mai 1955, conformément à la Loi des Chemins dc fer du Canada, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal, Que., 7 février 1955.Canadian Pacific Express Company, Le Surintendant, 39239-6-6-0 G.E.BEGLEY.Avis est par les présentes donné que tous les effets de bagage reçus avant le premier-jour de mars 1954, et non réclamés aux bureaux de la Canadian Pacific Railway Company, seront vendus aux enchères par MM.Fraser Bros., 901 rue St-Jacqucs, ouest, Montréal, à dix heures de l'avant-midi, mercredi, le 23 mars 1955, conformément à la Loi des Chemins de Fer du Canada, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal, le 3 février 1955.Canadian Pacific Railway Company Le Gérant du Service des Postes & Bagages, 39233-6-6-0 J.E.TWEEDY.Sales of Unclaimed Baggage NOTICE OF SALE Notice is hereby given that all goods received previous to the fifth day of May, 1954, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian Pacific Express Company at different points in the Provinces of New Brunswick, Nova Scotia and Quebec will be sold by Public Auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneers, at 128 King Street East; Toronto, Ont., at eleven o'clock in the forenoon on the fifth day of May, 1955, under authority of the Railway Act of Canada, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal, Que., February 7th, 1955.Canadian Pacific Express Company G.E.BEGLEY, 39239-6-6-0 Superintendant.Notice is hereby given that all baggage received prior to the first day of March 1954, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian Pacific Railway Company, will be sold by public auction to the highest bidder by Messrs.Fraser Bros., auctioneers, at 901 St.James St.West, Montreal at ten o'clock in the forenoon, on Wednesday, March.23rd, 1955, under the authority of The Railway Act of Canada, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal, February 3rd, 1955.Canadian Pacific Railway Company per J.E.TWEEDY, Manager, Mail and 39233-6-6-o Baggage Traffic.Vente \u2014 Loi de faillite Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 247 (1954).\"En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Joseph Bernard, Laval des Rapides, débiteur, & ClaudePerras, Syndic, Sale \u2014 Bakrupcy Act Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.247 (1954).\"In Bankruptcy\".In the matter of Bankruptcy of : Joseph Bernard, Laval des Rapides, debtor & Claude Perras, Trustee. 982 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 AVIS DE VENTE Avis public est.par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Désignation: Un emplacement situé en la ville de Laval des Rapides, connu et désigné comme étant le lot numéro quatre cent soixante-deux dc la subdivision officielle du lot numéro deux cent cinquante-six (256-402) aux dits plan et livre de renvoi officiels de la paroisse Ste-Martin, avec bâtisse dessus construite portant le numéro 83 avenue du Pacific, tel que le tout se trouve présentement, sans aucune exception et réserve.Sera vendu en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure pour le district de Montréal, (En faillite) rendu le 3 mars 1955, à l'enchère publique suivant la loi, pour ladite vente avoir l'effet du décret à la porte de l'Église paroissiale du Bon Pasteur, à Laval des Rapides, MARDI le DIX-NEUF AVRIL 1955, à ONZE heures de l'avant-midi.Conditions: comptant.En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 23^% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 8 mars 1955.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: Perras & Perras, Syndics, 4 Notre-Dame, est, Montréal.39426-10-2-o NOTICE OF SLAE Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit: Designation: An emplacement situate in the Town of Laval des Rapides, known and designated as being lot number four hundred and sixty-two of the official subdivision of lot number two hundred and fifty-six (250-402) on the said official plan and in the book of reference of the parish of St-Martin, with building thereon erected bearing number 83 Pacific Avenue, as the whole now stands, without any exception nor\" reserve.Shall be sold in virtue of a judgment of the Superior Court for the district of Montreal (In bankruptcy) rendered March 3, 1955, at public auction according to Law, so that the said sale will have the effect of a Sheriff's sale, at the parochial church door of Bon Pasteur, at Laval des Rapides, TUESDAY, APRIL NINETEENTH, 1955, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the purchaser shall pay Government rights of 2^4% m conformity with the Law.For other information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this eighth day of March, 1955.CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of: < Perras & Perras, Trustees, 4, Notre-Dame Street, East, Montreal, P.Q.39420-10-2 Ventes par licitation Canada, Province de Québec, district de Québec, dans la Cour Supérieure, N° 66,526.Edouard Boivin, industriel, de la cité de Sillery, Gabriel Boivin, industriel, de la cité de Québec, demandeurs, vs Dame Simone Boivin Prémont, de la cité de Québec, épouse séparée de biens de Robert Prémont, de la cité de Québec, Dame Marie Paule Boivin Jolin, épouse séparée de corps et de biens de J.Emile Jolin, de la cité de Québec, Dame Vve Germaine Boivin Boutet, veuve de feu J.Antoine Boutet, de la cité de Québec, défendeur, & Ledit Robert Prémont, de la cité de Québec, mis en cause aux fins d'autoriser et d'assister sa dite épouse, mis-en-cause.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour supérieure, siégeant à Québec, dans le district de Québec, le 17 janvier 1955, dans une cause dans laquelle Edouard Boivin, industriel, de la cité de Sillery, et Gabriel Boivin, industriel, de la cité de Québec, sont demandeurs, ordonnant la licitation de certain immeuble désigné comme suit, savoir: Les lots numéros un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix des subdivisions du lot originaire numéro mille quatre cent quatre-vingt-onze (1491-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du quartier Ste-Marie, en la cité de Montréal, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et notamment la maison portant le numéro municipal 1801 de Sales by Licitation Canada, Province of Quebec, district of Quebec, in the Superior Court, No.66,526.Edouard Boivin, manufacturer, of the city of Sillery, Gabriel Boivin, manufacturer, of the city of Quebec, plaintiffs, vs Simone Boivin Prémont, of the city of Quebec, wife separated as to property of Robert Prémont, of the city of Quebec, Marie Paul Boivin Jolin, wife separated as to bed and board of J.Emile Jolin, of the city of Quebec, Germaine Boivin Boutet, widow of the late J.Antoine Boutet, of the city of Quebec, and.the said Robert Prémont, to authorize his wife, defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is given that in virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at Quebec, in the district of Quebec, rendered on the 17th day of January 1955, in a case wherein the said Édou-art Boivin and Gabriel Boivin are plaintiffs and Dame Simone Boivin Prémont, Marie Paule Boivin Jolin and Germaine Boivin Boutet are defendants, ordering the licitation of certain immoveables described as follows, to wit: An immoveable known and designated as being composed of lots number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten of the official subdivision of the original lot one thousand four hundred ninety one (1491-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10) of the official cadastral plan and in the book of reference for ward Ste-Marie, of the city of Montreal, with all buildings thereon erected, circumstances and dependencies, being QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.II 983 l'avenue Delorimier à Montréal, l'outillage et la machinerie étant exceptés.L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le VINGT ET UN AVRIL 1955, à DIX heures TRENTE a.m., au bureau du protonotaire du district de Montréal, au palais de justice, à Montréal, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffa du protonotaire de ladite Cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire dc la dite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition «à fin dc conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elle seront forcloses du droit de la faire.Montréal, le 3 mars 1955.Les Procureurs de la défenderesse, Marie-Paul Boivin Jolin.LESAGE, TURGEON & BIENVENUE.39397-10-2-O Province dc Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 354,679.Armand Caron, demandeur, vs Albcrtinc Caron & al., défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure siégeant à Montréal dans le district de Montréal et rendu par l'Honorable juge François Caron, le 14 février 1955, dans une cause dans laquelle Armand Caron, employé civil de la Ville de Verdun, district de Montréal, est demandeur, et Albcrtine Caron de la Ville St-Laurent, épouse séparée de biens par contrat de mariage de Léandre Vallée agent d'assurance, et ce dernier partie aux présentes en autant que besoin est pour autoriser saditc épouse \u2014 et \u2014 Henri Caron, constable de la Ville de Lachine \u2014 et \u2014 Edouard Caron, chauffeur \u2014 et \u2014 Arthur Caron, commis ces deux dernier- de la Cité de Montréal, et tous du district de Montréal, sont défendeurs, ordonnant la licitation d'un immeuble désigné comme suit: Un emplacement ayant front sur la rue Ryde en la cité de Montréal, désigné comme étant les lots numéros cent cinq et cent six, de la subdivision officielle du lot originaire trois mille trois cent soixante-dix (3370-105 et 100) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, mesurant cinquante-deux (52) pieds de largeur par une profondeur de soixante-dix-huit pieds et huit dixièmes de pied (78.8), mesure anglaise et plus ou moins, avec la maison dessus érigée portant les numéros 2403, 2405, 2407 et 2409 de ladite rue Ryde, et dépendance et autres bâtisses sur ledit emplacement.L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le VINGT-HUIT AVRIL 1955, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi, dans la salle d'audience chambre 31 au Palais dc Justice à Montréal, Cour tenant, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du Protonotaire dc ladite Cour, et que toute opposition afin d'annuler, afin de charges, ou afin de distraire à ladite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de ladite Cour au moins 12 jours avant le the building bearing civic number 1801 of Delorimier Avenue, city of Montreal, but without the machinery and implements.The above described immoveables will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder, on the TWENTY FIRST day of APRIL next (1955), at half past TEN o'clock in the forenoon, at the office of the Prothono-tary of the Superior Court for the district of Montreal, at the Court House of Montreal, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the said Court.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation, must be filed at the office of the Prothonotary of the said Court, at least twelve days before the day fixed for the sales and adjudication, and any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; and, failing the parties to filed the said opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Montreal, this 3rd day of March, 1955.LESAGE, TURGEON & BIENVENUE, Attorneys for the defendant, Marie-Paulc Boivin Jolin.39397-lO-2-o Province of Quebec, district of Montreal Superior Court, No.354,679.Armand Caron, plaintiff, vs Albcrtine Caron & a)., defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is given that in virtue of a Judgment of the Superior Court sitting in Montreal in the district of Montreal on February 14th, 1955, in the case where Armand Caron, civil employee of the town of Verdun, district of Montreal, is plaintiff, and Albcrtinc Caron of ville St-Laurent, wife separate as to property by marriage contract of Léandre Vallée, insurance agent, and the said Léandre Vallée to authorize his said wife unto these presents, and Henri Caron constable of the city of Lachine, Edouard Caron, driver, and Arthur Caron, clerk, both of the city of Montreal, and all of the district of Montreal, are the defendants, ordering the licitation of the immoveable designated as follows: An emplacement fronting on Rydc Street in the city of Montreal designated as lots number one hundred and five and one hundred and six of the official subdivision of the original lot three thousand three hundred and seventy (3370-105) and 100) of the official plan and book of reference of the parish of Montreal, containing 52 feet in width by 78.8 feet deep, English Measure more or less, with house thereon erected bearing number 2403, 2405, 2407 and 2409 of the said Rydc Street, and other buildings and appurtenances thereon erected on the said emplacement The above described immoveable will be sold by auction and adjuged to the highest and last bidder on the TWENTY-EIGHTH of APRIL 1955, at HALF past TEN o'clock in the forenoon, Montreal, the said sale to be made subject to the charges clauses and conditions mentioned in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the said Court.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at 984 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication et que toute opposition afin de conserver devra être déposée dans les 6 jours après l'adjudication; et à défaut par les parties de déposer lesditcs oppositions dans les délais prescrits par les présentes, elles seront forcloses de droit de le faire.Un dépôt de $1.200.00 sera exigé avant la vente de tout offrant ou enchérisseur.Montréal, le 3 mars, 1955.Vraie copie Les Procureurs du demandeur.GUÊRIN & PINARD.Les Procureurs du demandeur, 39453-1 l-2-o GUÉRIN & PINARD.least 12 days before thè day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; and failing the interested parties to file the said opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.A deposit of $1,200.00 shall be exacted from each and every bidder.Montreal, March 3rd, 1955.True copy GUÉRIN & PINARD, Attorneys for the plaintiff.GUÉRIN & PINARD, 39453-1 l-2-o Attorneys for the plaintiff.VENTES PAR SHÊRLFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ARTHABASKA Fieri Fadas de Bonis et de Terris District d'Arthabaska.En la Cour de l'Échiquier du Canada, N° 98387.Dans l'affaire de la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, et amendements, et dans l'affaire de FRANK BOUCHARD, (FILS), gérant d'une compagnie de la ville de Drummondville, Province «le Québec.\"Le lot numéro cent trente-huit de la subdivision du lot numéro cent trente (130-138) du cadastre du canton de Grantham, comté de Drummond.'* Pour être vendu à la porte de l'église de l'Immaculée Conception, à Drummondville-Ouest, le JEUDI le VINGT ET UN AVRIL 1955 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, FÉLIX HOULE.Arthabaska, le 14 mars 1955.39469-11-2-0 Fieri Fadas de Bonis et de Terris District d'Arthabaska Comté de Drummond Cour de Magistrat, ( T ES COMMISSAIRES N° 10-631.< -L* D'ÉCOLES du village (.de Drummondville-Ouest, comté de Drummond, demandeurs, vs FRANK BOUCHARD, FILS, Drummondville, gérant d'une compagnie défendeur.Trois terrains situés au village de Drummondville-Ouest, connus et désignés comme étant les numéros cent trente-neuf, cent cinquante^neuf, et cent soixante des subdivisions officielles du lot numéro cent trente (130-139, 159, 160) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Grantham, comté de Drummond.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de L'Immaculée Conception, à Drummondville-Ouest, le JEUDI le VINGT ET UN AVRIL 1955 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, FÉLIX HOULE.Arthabaska, ce 10 mars 1955.39468-11-2-0 SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA Fieri Fadas de Bonis et de Terris District of Arthabaska In the Exchequer Court of Canada, No.98387.In the Matter of the INCOME TAX ACT, and amendments, and in the matter of FRANK BOUCHARD, (SON), Manager of a company in the town of Drummondville, Trovince of Quebec.\"Lot number one hundred and thirty-eight of the subdivision of lot one hundred and thirty (130-138) of the cadastre of the township of Grantham, county of Drummond.\" To be sold at the door of the church of the Immaculate Conception at Drummondville-West, on THURSDAY, the TWENTY-FIRST day of APRIL, 1955, at TEN o'clock in the forenoon.FÉLIX HOULE, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, March 14th, 1955.- 39469-11-2 Fieri Fadas de Bonis et de Terris District of Arthabaska County of Drummond Magistrate's Court, / THE SCHOOL COM-No.10-631.< f MISSIONERS of the (.village of Drummondville-West, county Drummond, plaintiffs, vs FRANK BOUCHARD, SON, Drummondville, manager of a company, defendant.Three lots of land situate in the village of Drummondville-West, known and designated as being numbers one hundred and thirty-nine, one hundred and fifty-nine and one hundred and sixty (130-139, 159, 160) on the official plan and in the book of reference of the cadastre of the township of Grantham, county of Drummond.To be sold at the door of the parochial church of the Immaculate Conception at Drummondville-West, on THURSDAY, the TWENTY-FIRST day of APRIL, 1955, at TWO o'clock in the afternoon.FÉLIX HOULE, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, March 16th, 1955.39468-11-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 985 BEDFORD Canada \u2014 Province de Quebec District de Bedford Cour Supérieure, ( \"DERNANDO TOMASSI-N° 5815.M NI, d e m iindcur, v s I ROBERT ROCHETTE, défendeur.Comme appartenant au défendeur.Une propriété de ferme située dans la municipalité de Bolton West et connue au cadastre officiel pour le canton dc Bolton comme étant les lots numéros 22S, 102, 105, et 129, avec bâtisses dessus y érigées, sauf et excepté certaines parties de ces derniers lots.Pour être vendu à la porte de l'église catholique de St-Edouard de Knowlton, à Knowlton, comté de Brome district dc Bedford, le TRENTE MARS 1955.à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, A.ST.MARTIN.Palais de .Justice, Swectsburg, Québec, 39328-8-2-o BONAVENTURE ( Canada \u2014 Province de Québec District de St.-François \u2014 Sherbrooke Cour Supérieure, ( TRÈNE B ÉLANCER, ren-N° 12,967.< A tière domiciliée au N° 405, \\ rue Elizabeth, à Sherbrooke, district de St-François, demanderesse, vs ADRIEN (ïARAND, autrefois de Guité et maintenant résidant à Maria, district de Bonaventure, défendeur.Les lots numéros vingt-quatre, trcnte-B et trcnte-C, (24, 30-B et 30-C) du quatrième rang, du canton de Maria.Les lots numéros vingt-trois et vingt-quatre (23 et 24) du cinquième rang, du même canton.Avec bâtisses dessus érigées.Pour être vendus à la porte de l'église de Maria, comté et district de Bonaventure, le TRENTE-ET-UNIÈME jour de MARS, mil neuf cent cinquante cinq, (31 mars 1955), à DIX heures dc l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, F.J.LcGRESLEY.New Carlisle, 21 février 1955.393l7-8-2-o BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, (\"RERNANDO TOMASSINI.No.5815.{ -L plaintifr.vs ROBERT ( ROCHETTE, defendant.As belonging to the defendant.A farm situate in the municipality of Bolton West and known on the official cadastre for the township of Bolton as being lots numbers 228, 102, 105, and 129, with buildings thereon erected, save and except certain part of these last lots._ To be sold at the Catholic church door of St-Édouard de Knowlton, at Knowlton, county of Brome, district of Bedford, on MARCH THIRTIETH 1955, at TEN o'clock in the forenoon.A.ST.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Swectsburg, Quebec.39328-8-2 BONAVENTURE Canada \u2014 Province of Quebec District of St-Francis \u2014 Sherbrooke Superior Court, i TRÈNE BÉLANGER, pen-No.12.967.< sionner, domiciled at No.I 405.Elisabeth Street, at Sherbrooke, district of St-Francis, plaintiff, vs A-DRIEN GARAND, formerly of Guité and now residing at Maria, district of Bonaventure.defendant.Lots nos twenty-four.thirty-B and thirty-C, (24, 30-B ami 30-C) of the 4th range, township of Maria.Lots Nos twenty-three and twenty-four.(23 and 24) of the fifth range, township of Maria.With buildings thereon erected.To be sold at the parochial church door of Maria, countv and district of Bonaventure.on the THIRTY-FIRST day of MARCH, one thousand nine hundred ami fifty-five, (31st of March 1955) at TEN o'clock in the forenoon.F.J.LeGRESLEY, Sheriff's Office, Sheriff.New Carlisle.February 21st 1955 39317-8-2-o CHICOUTIMI District de Roberval District electoral du Lac St.-.Jean Cour du Magistrat, t T A B A'Nt Q U E D E Siégeant à Alma.J ^ MONTRÉAL, ayant I bureau à Naudville, corporation légalement constituée, demanderesse; vs JACQUES MARTEL et al, tous deux cultivateurs, de St-Nazaire.défendeurs, contre le défendeur Jacques Martel: Le lot de terre connu et désigné sous le No.29 du rang 5, canton Taché, avec bâtisses dessus .construites, appartenances et dépendances, sauf à distraire emplacement «le Léo Néron.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Louis Nazaire, JEUDI, le TRENTE ET UNIÈME jour du mois de MARS 1955, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi.le 21 février 1955.39323-8-2-o CHICOUTIMI District of Roberval Electoral District of Lake St.John Magistrate's Court.fTHE BANK of MONT-Sitting at Alma.< \u2022*\u2022 REAL, having office I at Naudville.corporation legally constituted, plaintiff; vs JACQUES MARTEL et al, both farmers, of St.Nazaire, defendant, against the defendant Jacques Martel: A lot of land known and designated as No.29, range 5, township of Taché, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, save and except the emplacement of Léo Néron.To be sold at the parochial Church door of St.bonis Nazaire, THURSDAY the THIRTY-FIRST day of the month of MARCH 1955.at THREE o'clock in the afternoon.RENÉ DELISLE, Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, February 21st, 1955.39323-8-2 986 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mars 1955, Tome 87, N° 11 GASPÉ Fieri Facias de Bonis et de Terris GASPÉ Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure, / t ALPHONSE PELLETIER Superior Court, rJ ALPHONSE PELLE! Rimouski, P.Q.orate and existing in virtue of the Quebec Education Act, plaintiff, vs MARC A.LEGUERRIER, of the village of Fort Coulonge, district of Pontiac.defendant.\"Lot No.330.according to the official plan and book of reference for the village of Fort Coulonge, district of Pontiac, with all buildings and improvements thereon erected.\" To be sold at the Registrar's office for the coun-tv of Pontiac, in Campbell's Bay, Que., on TUESDAY the TWENTY-NINTH day of MARCH, in the year one thousand nine hundred and fifty-five at TEN of the clock in the forenoon.DOMINIC SLOAN, Sheriff's Office, Sheriff.Campbell's Bay, Que., February, 21st, 1955.39340-8-2-o QUEBEC Quebec, to wit : ( t G.POWER SAWMILLS No.74411.< -l-'- LTD., corporation legally ( incorporated having its principal place of business at Giffard, Quebec, against OMER GIGUÈRE, residing and domiciled at Ste-Anne de Beaupré, county of Montmorency, district of Quebec.A plot of land forming part of the northeast half of lot number two hundred and twenty-two (Pt.of N.E.}4 of 222) of the official cadastre for the parish of Ste-Anne; measuring fifty feet in width, by one hundred feet in depth, English measure; bounded on the south by the municipal road, on the east, by Siméon Giguère, on the west, by Albert Cassista and on the north, by Joseph Giguère.With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Ste-Anne de Beaupré, county of Montmorency, the FIRST day of APRIL next, at TEN o'clock in the morning.ALBERT F.RACE1TE, Sheriff's Office.Deputy Sheriff.Quebec, March 2nd, 1955.39371-9-2 [First insertion: March 5th, 1955] [Second insertion: March 19th, 1955] Fieri Facias Quebec, to wit : , TE A N - B A P TI ST E B O U -No.75-826.oration.958 Valor Lithium Mines Limited.959 Ministère des Finances: Assurances: Affiliated F M Insurance Company.975 Sièges sociaux: Agences d'Assurance Sept-Iles Ltée.975 Annuaire Marcotte Ltée.976 Copper Cliff Consolidated Mining Corporation .976 Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited.976 Forêt-Québec Ltée.975 Soumissions: Beauceville-Est, commissaires d'écoles de la ville de.979 Lachine, commissaires d'écoles de la cité de.977 Richmond, ville de.976 St-Romuald d'Etchemin, paroisse de.980 Ventes d'effets non-réclamés: Canadian Pacific Express Company.981 Canadian Pacific Railway Company.981 Vente, Loi de faillite: Bernard, Joseph.981 Ventes par licitation: Boivin et al vs Prémont et al.982 Caron vs Caron et al.983 Vente pour taxes: Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited.949 Guarantee Commercial Exchange Inc.950 H.Wexler Sons & Company.950 Imperial Tire Sales Limited.950 Jean Bourbonnière Hardware Limited.951 J.L.Gingras Limitée.951 Ken Story Garage Ltd.951 Lake Beauport Industries Ltd \u2014 Les Industries Lac Beauport Ltée.952 Les Constructions de la Haute Ville de Châteauguay Ltée.952 Les Immeubles Du Mont Ltée.952 Maison Alyse Inc.v 953 Northland Lithium Mines Ltd.953 Peppe's Restaurant (Quebec) Inc.954 Plaza Realty Inc.954 Radio City Music Hall Inc.954 Salaison Lafontaine Packing Inc.955 Shefford Copper Mines Ltd.955 St.Johns Ready-Mix Co.Ltd.955 Thetford Transport Limitée.956 Wilks & Company Ltd.956 Wolfus & Adelstein Fur Mfg.Ltd.956 Supplementary Letters Patent: Acme Molybdenite Mining Company Limited.957 Bouchaire Inc.957 Conro Development Corporation Limited .957 Forêt-Québec Ltée.958 j Maison Familiale St-Joseph.958 Progressive Color & Chemical Co.Limited.?.958 St.Siméon Uranium Corporation.958 Valor Lithium Mines Limited.959 Department of Finance: Insurance: Affiliated F M Insurance Company.975 Head Offices: Agences d'Assurance Sept-Iles Ltée.975 Annuaire Marcotte Ltée.976 Copper Cliff Consolidated Mining Corporation .976 Emdeco Limitée \u2014 Emdeco Limited.976 Forêt-Québec Ltée.975 Tenders: Beaucevillc-East, School Commissioners of the town of.979 Lachine, School Commissioners of the city of.977 Richmond, town of.976 St-Romuald d'Etchemin, parish of.980 Sales of Unclaimed Baggage: Canadian Pacific Express Company.981 Canadian Pacific Railway Company.981 Sale, Bankruptcy Act: Bernard, Joseph.981 Sales by Licitation: Boivin et al vs Prémont et al.982 Caron vs Caron et al.983 Sale for Taxes: Argenteuil, comté de 959 Argenteuil, county of 959 _QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 19th, 1955, Vol.87, No.11 993 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer.VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Arthabaska: Arthabaska: Commissaires d'écoles du village de School Commissioners of the village of Drummondvillc-Ouest vs Bouchard, Drummondville-West vs Bouchard, fils.984 son.984 Loi de l'impôt sur le revenu vs Bou- Income Tax Act vs Bouchard, son.984 chard, fils.984 Bedford: Bedford: Tomassini vs Rochette.985 Tomassini vs Rochette.985 Bonaventure: Bonaventure: Bélanger vs Garand.985 Bélanger vs Garand.985 Chicoutimi: Chicoutimi: La Banque de Montréal vs Martel et al.985 The Bank of Montreal vs Martel et al.985 Gaspé: Gaspé: J.Alphonse Pelletier Ltée vs Lafon- ¦ J -Alphonse Pelletier Ltée vs Lafontaine.986 taine.:.986 Kamouraska: Kamouraska: La Banque Provinciale du Canada vs La Banque Provinciale du Canada vs Poliquin.986 Poliquin.986 Montréal: Montreal: Silverstone vs Rousseau.986 Silverstone vs Rousseau.986 Pontiac: Pontiac: Commissaires d'écoles de Mansfield vs School Commissioners of Mansfield vs Leguerrier.987 Leguerrier.987 Québec: Quebec: Bouchard vs Guérin.987 Bouchard vs Guérin.987 L.G.Power Sawmills Ltd.vs Giguère.987 L.G.Power Sawmills Ltd.vs Giguère.987 Roberval: Roberval: Grenier & Fils Ltée vs Cossctte.988 Grenier & Fils Ltée vs Cossette.988 L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm.Credit Bureau vs Simard.989 vsSimard.989 ROUVN-NORANDA : RoUVN-NoRANDA: Lefebvre vs Vaillant.990 Lefebvre vs Vaillant.990 Saguenay: Saguenay: Traders Finance Corp.Ltd.vs Foster.990 Traders Finance Corp.Ltd.vs Foster.990 39437-0 39437-0 i fi "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.