Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 2 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1955-04-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 87, N° 13 1063 Vol.87, No.13 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 2 avril 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, April 2nd, 1955 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable, matter. 1064 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1956, Tome 87, N° 13 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De Elus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder i publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les a*vis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933\u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their lbngth or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.38933 \u20141-52 Lettres patentes (P.G.10353-55) Agences Joubert Inc.Joubert Agencies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit février 1955, constituant en corporation: Maurice Joubert, agronome industriel, de Saint-Vincent-de-Paul, Léandre Prévost, avocat, de Montréal, et Edouard Martel, avocat, d'Outre-mont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'instruments, outillage et équipement agricoles, industriels et commerciaux, sous le nom de \"Agences Joubert Inc.\u2014 Joubert Agencies Inc.\", avec un capital divisé en 500 actions privilégiées de $100 chacune et en 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie sera à 10905, rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Letters Patent (A.G.10353-55) Agences Joubert Inc.Joubert Agencies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February, 1955, incorporating: Maurice Joubcrt, industrial agronomist, of Saint-Vincent-de-Paul, Léandre Prévost, advocate, of Montreal, and Edouard Martel, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in instruments, tool equipment and farm implements, industrial and commercial, under the name of \"Agences Joubert Inc.\u2014 Joubert Agencies Inc.\", with a capital stock divided into 500 preferred shares of $100 each and into 2,000 common shares of no par value.The head office of the company will be at 10905 Lajeunesse St., Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.IS 1065 Daté du bureau du Procureur général, le dix- Dated at the office of the Attorney General, huit février 1955.this eighteenth day of February, 1955.¦L'Assistant-procureur général, C.E.CANTIN, 39524-0 C.E.CANTIN.39524 Deputy Attorney General.(P.G.10460-55) Aniccca Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatre février 1955, constituant en corporation: Philip Meyerovitch, avocat et conseil en loi de la Reine, de Montréal, Hyman Solomon, avocat, de Ville Mont-Royal, et Morris Shuter, gérant de bureau, de ville St-Laurcnt, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements et fournitures, sous le nom de \"Amceca Trading Corporation\", avec un capital total de $10,000, diviséen 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10-187-55) Apa Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu deja première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatrième jour de février 1955, constituant en corporation: Richard Dale Weldon, Edmond Jacques Courtois, Ross Trenholme Clarkson et John William Durnford, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Apa Investments Ltd.\", avec un capital-actions de 8,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à 6333 boulevard Décarie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-quatrième jour de février 1955.L'Assis tan t-procu reu r général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10662-55) Associated Brick Manufacturers, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorzième jour de février 1955, constituant en corporation: Israël David Marcus, industriel, Valentin Bercovici-Plopul, consultant et Betty Marcus Bercovici-Plopul, ménagère, épouse séparée de biens dudit Valentin Bercovici-Plopul et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Associated Brick Manufacturers, Limited\", avec un capital total de $80,000, divisé en 800 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.10460-55) Aniccca Trading Corporation ' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1955, incorporating: Philip Meyerovitch, advocate and Queen's Counsel, of Montreal, Hyman Solomon, advocate, of the town of Mount Royal, and Morris Shuter, office manager, of the town of St.Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and furnishings, under the name of \"Ameeca Trading Corporation\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10187-55) Apa Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1955, incorporating: Richard Dale Weldon, Edmond Jacques Courtois, Ross Trenholme Clarkson and John William Durnford, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Apa Investments Ltd.\", with a capital stock of 8,000 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at 6333 Décarie Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10662-55) < Associated Brick Manufacturers, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Israël David Marcus, industrialist, Valentin Bercovici-Plopul, consultant, and Betty Marcus Bercovici-Plopul, housewife, wife separate as to property of the said Valentin Bercovici-Plopul, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, under the name of \"Associated Brick Manufacturers, Limited\", with a total capital stock of $80,000, divided into 800 shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 1066 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General, quatorzième jour de février 1955.this fourteenth day of February, 1955.L'Assistant-procureur général.C.E.CANTIN, 39524 C.E.CANTIN.39524-o Deputy Attorney General.(P.G.10372-55) Barth & Gaty Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de février 1955, constituant en corporation: Samuel Léon Mendelsohn avocat, et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Léo Rosentzvcig, Daniel Morris, avocats, de Montréal et Manuel Shacter, avocat, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers d'assurances, sous le nom de \"Barth & Gaty Limited\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de SI00 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10454-55) Bcauce Vidéo Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Armand Catellier, radio-technicien, Josa-plat Poulin, assistant-gérant, L.-Ph.Jolicœur, entrepreneur-électricien, Syllas Berberi, industriel, et Adrien Girard, agent, tous de Ville Saint-Georges, district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à opérer un ou des systèmes dits d'Antenne-Communauté afin de fournir un signal de télévision à des clients ou abonnés par un cable raccordé à leur appareil récepteur à leur domicile, sous le nom de \"Beauce Vidéo Limitée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 400 actions ordinaires de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Saint-Georges, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10405-55) Bcauccvillc Sash & Door Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize février 1955, constituant en corporation: Léo Grondin, commerçant, Adalbert Fortin, Gérard Fortin, industriels, Henri-Louis Poulin, contremaître, de Beauceville Ouest, et Jean-Paul Roy, cultivateur, de Beauceville Est, tous du district judiciaire de Beauce, pour les objets suivants: Exploiter des usines pour travailler le bois en planches, fabriquer des portes, chAssis, meubles et divers ouvrages de boiserie, vendre des (A.G.10372-55) Barth & Gaty Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Samuel Léon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Léo Rosentzvcig.Daniel Morris, advocates, of Montreal, and Manuel Shacter, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, under the name of \"Barth & Gaty Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.* Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10454-55) Beauce Vidéo Limitée Notice is hereby given that under Part I o the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February 1955, incorporating: Armand Catellier, radio-technician, Josaphat Poulin, assistant manage:, L.-Ph.J&icceur, electrical contractor, Syllas Berberi, industrialist, and Adrien Girard, agent, all of the town of Saint Georges, judicial district of Beauce, for the following purposes: To carry on a business consisting of operating one or several systems of a so-called Community Aerial with the object of furnishing television signals to clients or subscribers by means of a cable connected to a receiving apparatus in their homes, under the name of \"Beauce Vidéo Limitée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 400 common shares of $50 each.The head office of the company will be at the town of Saint Georges, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General,' this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10405^55) Beauceville Sash & Door Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Léo Grondin, dealer, Adalbert Fortin, Gérard Fortin, industrialists, Henri-Louis Poulin, foreman, of Beauceville-West, and Jean-Paul Roy, farmer, of Beauceville-East, all of the judicial district of Bcauce, for the following purposes: To operate factories for working board wood, manufacture doors, sashes, furniture and various types of woodwork, sell building materials and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.18 1067 matériaux de construction et exercer le commerce de produits forestiers, sous le nom de \"Beauceville Sash & Door Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beauceville, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P- G.10428-55) Bclpark Investment Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en daté du vingt-troisième jour de février 1955, constituant en corporation: David Zuncnshine, constructeur, Hazel Zuncnshine, ménagère, épouse séparée de biens de David Zuncnshine et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de Montréal et Ann R.Caplan, secrétaire, fille majeure, usant de ses droits, d'Outrc-mont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Belpark Investment Co.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10333-55) Biais Téléphone Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Frank Biais fils, industriel, Jeanne Robi-taille-Blais, épouse contractuellement séparée de biens dudit Frank Biais, tous deux de Malartic, district judiciaire d'Abitibi, et Jacques Angers, comptable agréé, de Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants: Exploiter, maintenir un réseau téléphonique,-sous le nom de \"Biais Téléphone Inc.\", avec un capital total de $500,000, divisé en 90,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune et en 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Malartic, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10504-55) Bral Furniture Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatrième jour de février 1955, constituant en corporation: Horace Friedman, avocat, Wolfe Friedman, étudiant, Aimé Mignault, gérant, et Jeanne Le Sieur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: deal in forestry products, under the name of \"Beauceville Sash & Door Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company will be at Beauceville, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10428-55) Belpark Investment Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of February, 1955, incorporating: David Zunenshine, builder, Hazel Zuncnshine, housewife, wife separate as to property of David Zunenshine, and by the latter duly authorized for these preents, both of Montreal, and Ann R.Caplan, secretary, fille majeure usant de ses droits, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Bclpark Investment Co.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10333-55) Biais Téléphone Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Frank Biais, Jr., industrialist, Jeanne Robitaille-Blais, wife contractually separate as to property of the said Frank Biais, both of Malartic, judicial district of Abitibi, and Jacques Angers, chartered accountant, of Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda, for the following purposes: To operate and maintain a telephone system, under the name of \"Biais Téléphone Inc.\", with a total capital stock of $500,000, divided into 90,000 common shares of a par value of $5 each and 10,000 preferred shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Malartic, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10504-55) Bral Furniture Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1955, incorporating: Horace Freidman, advocate, Wolfe Friedman, student, Aimé Mignault, manager, and Jeanne Le Sieur, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: 1068 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 Manufacturer et faire le commerce de meubles et fournitures de maison et de bureau, sous le nom de \"Bral Furniture Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune e*t 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8800 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-quatrième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10440-55) BronfeiKKnitting Mills Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Samuel Bronfen, Norman Mayle, manufacturiers, et Lillian Lazare, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements tricotés; produits en métal et en plastique, sous le nom de \"Bronfen Knitting Mills Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI00 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10429-55) Caromil Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit février 1955, constituant en corporation: Roméo Cadieux, industriel, Roger Millette et Germain Cadieux, ces deux derniers entrepreneurs, tout de Boucherville, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, constructeurs et excavateurs, sous le nom de \"Caromil Construction Inc.\", avec un capital total de 825,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.v .Le siège social de la compagnie sera à Boucherville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10281-5.5) Charward Holdings Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de février 1955, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Arono-vitch et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: To manufacture and deal in household, office furniture and furnishings, under the name of \"Bral Furniture Corporation\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and into 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at 8800 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10440-55) Bronfen Knitting Mills Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Samuel Bronfen, Norman Mayle, manufacturers, and Lillian Lazare, secretary, fille majeure, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitted wearing apparel; metal and plastic products, under the name of \"Bronfen Knitting Mills Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10429-55) Caromil Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the eighteenth day of February 1955, incorporating: Roméo Cadieux, industrialist, Roger Millette and Germain Cadieux, the two latter contractors, all of Boucherville, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors, builders and excavators, under the name of \"Caromil Construction Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Boucherville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of February 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10281-55) \u2022 Charward Holdings Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Shuster, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1069 Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Charwiird Holdings Corporation\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera a/s de MM.Margolese & Margolesc comptables agréés, 1 54 1 rue Crescent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTINr (P.G.10459-55) Chelnor Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de février 1955, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Arono-vitch et Abraham Shustcr, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur?généraux, sous le nom de \"Chelnor Enterprises Inc.\", avec un capital-actions divisé en 300 actions ordinaires sans valeur au pair et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3300 avenue Kent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10288-55) City Petroleum Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Adrien Rousse, commerçant, Louis-Philippe Gaudet, voyageur, et Cecilia Daoust Rousse, ménagère, épouse séparée de biens du-dit Adrien Rousse, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands d'huile en général, sous le nom de \"City Petroleum Company Ltd.\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $25 chacune et en 1,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7396, rue DeGaspé, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10556-55) City Tourist Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq février 1955, constituant en corporation: Yves Royer, Pierre Bienjonetti, avocats, et Claude Royer, notaire, tous des cité et To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Charward Holdings Corporation\", with a capital stock divided into 1,000 common shares of no par value and 1,000 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be c/o Messrs.Margolese & Margolesc, chartered accountants, 1541 Crescent St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10459-55) Chelnor Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Sinister, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, under the name of \"Chelnor Enterprises Inc.\", with a capital stock divided into 300 common shares of no par value and 1,000 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at 3300 Kent Ave., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10288-55) City Petroleum Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters pavent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Adrien Rousse, dealer, Louis-Philippe Gaudet, traveller, and Cecilia Daoust Rousse, housekeeper, wife separate as to property of the said Adrien Rousse, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of oil merchants in general, under the name of \"City Petroleum Company Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of a par value of $25 each and into 1,200 preferred shares of a par value of $25 each.The head office of the company will be at 7396, DeGaspé Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10556-55) City Tourist Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of February, 1955, incorporating: Yves Royer, Pierre Bienjonetti, advocates, and claude Royer, Notary, all of the city and judi- 1070 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 district judiciaire de Québec, pour les objets, suivants: Exercer le commerce qui consiste à fournir des chauffeurs d'automobiles compétents et des guides licenciés aux touristes en particulier et au public en général, sous le nom de \"City Tourist Service Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé-en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10627-55) Club de Golf Levis Golf Club Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix mars 1955, constituant en corporation: Ambrose Mewett, secrétaire-trésorier de Eastern Canada Steel & Iron Works Ltd., de Québec, Jules Côté, agent commercial, et John Marmen, marchand, ces deux derniers de Levis, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Posséder et entretenir un club de golf, un chalet, dépendances et autres accessoires, sous le nom de \"Club de Golf Levis Golf Club\", avec un capital total de $99,000, divisé en 990 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix mars 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-o C.E.CANTIN.(P.G.10424-55) Concord Textiles Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par* tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf février 1955, constituant en corporation: Moses Samuel Yelin, avocat, Anna Mikula et Esther Monson, secrétaires, filles majeures usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de textiles d'aucune sorte et description, sous le nom de \"Concord Textiles Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10602-55) Corporation de l'Institut d'Optique de Montréal Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mars 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Lippcns, pharmacien-optométriste, d'Outremont, Albert Dugal, phar- cial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of providing qualified automobile drivers (chauffeurs) and licensed guides to the tourists in particular and to the public in general, under the name of \"City Tourist Service Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10627-55) Club de Golf Levis Golf Club Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March 1955, incorporating: Ambrose Mewett, secretary-treasurer of Eastern Canada Steel & Iron Works Ltd., of Quebec, Jules Côté, business agent, and John Marmcn, merchant, the two latter of Levis, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To own and maintain a golf club, club-house, dependencies and other accessories, under the name of \"Club de Golf Levis Golf Club\", with a total capital stock of $99,000, divided into 990 shares of $100 each.The head office of the company will be at Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of March 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10424-55) Concord Textiles Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of February, 1955, incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Anna Mikula and Esther Monson, secretaries, filles majeures usant de leurs droits, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in textiles of every kind and description, under the name of \"Concord Textiles Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and into 300 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10602-55) Corporation de l'Institut d'Optique de Montréal Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of March 1955, to incorporate as a corporation without share capital : Paul Lippens, druggist and optometrist, of Outremont, Albert Du- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1071 macien, de Verdun, et Bertha' Métivier, secrétaire du bureau, l'Union Médicale du Canada, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Instituer un centre d'enseignement et de recherches scientifiques en optique théorique et appliquée, sous le nom de \"Corporation de l'Institut d'Optique de Montréal\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers (pie la corporation peut posséder, est de 850,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mars 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10421-55) Daro Textile Contractors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de février 1955, constituant en corporation: Lily Bercusson, ménagère, épouse séparée de biens de David Rosenberg et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, David Rosenberg, entrepreneur, tous deux de Montréal et Issie Druckman, contremaître, d'Outremont, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre et exercer le commerce comme entrepreneurs généraux dans la confection de vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Daro Textile Contractors Inc.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10279-55) Debron Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch et Abraham Sinister, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Debron Holdings Inc.\", avec un capital actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au s/d Messieurs Margolese & Margolese, comptables agréés, 1541 nie Crescent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10418-55) Décaric Towers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été gal, druggist, of Verdun, and Bertha Métivier, office secretary, l'Union Médicale du Canada, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To found a centre for teaching and scientific research in theoretical and applied optics, under the name of \"Corporation de l'Institut d'Optique de Montréal\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of March 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10421-55) Daro Textile Contractors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Lily Bercusson, housewife, wife separate as to property of David Rosenberg, and duly authorized by him for the purposes of these presents, David Rosenberg, contractor, both of Montreal, and Issie Druckman, foreman, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on the business of general contractors of wearing apparel of all kinds, under the name of \"Daro Textile Contractors Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10279-55) Debron Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Sinister, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Debron Holdings Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares of no par value and into 1,000 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be c/o Messrs.Margolese & Margolese, chartered accountants, 1541 Crescent St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10418-55) Décarie Towers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1072 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huitième jour de février 1955, constituant en corporation: Samuel ('liait, Harry L.Arono-vitch et Abraham Sinister, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Décarie Towers Inc.\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair, 100 actions privilégiées, catégorie \"A\" d'une valeur au pair de 810 chacune et 1,000 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 ^SZ.E.CANTIN.(P.G.10416-65) Dcmers Rimouski Ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dp Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Paul-Emile Gagnon, Gilles Gagnon, avocats, et Lucienne Michaud, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, tous de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer le commerce de pneus et autres objets en caoutchouc, composé ou synthétique, de ferronnerie, quincaillerie, bimbeloterie, appareils électriques, radios, télévisions et accessoires pour maison et automobile, sous le nom de \"Deniers Rimouski Ltée\", avec un capital total de 830,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of February, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, and Abraham Shus-ter.all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Décarie Towers Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares of no par value, 100 Class \"A\" preferred shares of the par value of 810 each and 1,000 class \"B\" preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10416-55) Deniers Rimouski Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: Paul-Êmile Gagnon, Gilles Gagnon, advocates, and Lucienne Midland, secretary, spinster in use of her rights, all of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To deal in tires and other objects of compound or synthetic rubber, ironware, hardware, knick-nacks, electrical appliances, radios, televisions and accessories for house and automobile, under the name of \"Deniers Rimouski Ltée\", with a total capital stock of $30,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and into 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10386-55) Dominion Acoustic Tile Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze février 1955, constituant en corporation: Rodney'Alexander Patch, avocat et conseil en loi de la Reine, Kenneth Charles Mackay, Austin Stuart Hyndman, avocats, tous trois de Montréal et Donald Edward MacKenzie, avocat, de Lachine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturiers de tuile acoustique et entrepreneurs et installer des tuiles de toutes sortes, sous le nom de \"Dominion Acoustic Tile Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1055 avenue Blair, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(A.G.10386-55) Dominion Acoustic Tile Ltd.v Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1955, incorporating: Rodney Alexander Patch, advocate and Queen's Counsel, Kenneth Charles Mackay, Austin Stuart Hyndman, advocates, all three of Montreal, and Donald Edward MacKenzie, advocate, of La-chine, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of acoustic tile manufacturers and contractors and to install tile of all kinds, under the name of \"Dominion Acoustic Tile Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1055 Blair Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1073 (P.G.10410-55) Dominion Industrial Centre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-septième jour de février 1955, constituant en corporation: Arthur Garmaise, David Goodman, avocats, Yvonne Bélanger, secrétaire, tous trois de Montréal et Melvin Rothman, étudiant, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de propriétés immobilières, sous le nom de \"Dominion Industrial Centre Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(A.G.10410-55) Dominion Industrial Centre Inc.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: Arthur Garmaise, David Goodman, advocates, Yvonne Bélanger, secretary, all three of Montreal, and Melvin Rothman, student, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveable property, under the name of \"Dominion Industrial Centre Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Demity Attorney General.(P.G.10395-55) Dunham Creameries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize février 1955, constituant en corporation: Lynwood M.Rowse, gérant, Edward L.McCrum et Paul-Emile Piette, contremaîtres, tous de Dunham, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Acheter et vendre du lait, de la crème, crème glacée, beurre et fromage et tous les sous-produits du lait et de la crème, sous le nom de \"Dunham Creameries Inc.\", avec un capital total de $85,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dunham, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10442-55) Esquisile Furs Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Weutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de février 1955, constituant en corporation: Leonora Schweid Scharf, marchande publique, épouse séparée de biens de Michel Scharf, fourreur, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Irwin Gliserman, avocat et Mœ Ackman, étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de fourrures, sous le nom de \"Esquisite Furs Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune et 50 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(A.G.10395-55) Dunham Creameries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Lynwood M.Rowse, manager, Edward L.McCrum and Paul-Émilc Piette, foremen, all of Dunham, judicial district of Bedford for the following purposes: To buy and sell milk, cream, ice cream, butter and cheese and all by-products of milk and cream, under the name of \"Dunham Creameries Inc.\", with a total capital stock of $85,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Dunham, in the judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10442-55) Esquisite Furs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Leonora Schweid Scharf, marchande publique, wife separate as to property of Michel Scharf, furrier, and duly authorized by him for the purpose of these presents, Irwin Gliserman, advocate, and Mce Ackman, law student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, under the name of \"Esquisite Furs Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 50 common shares of $100 each and into 50 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.Q.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General. 1074 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 (P.G.10423-55) Filtex du Québec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Lucie-Anne Dupuis Roberge, épouse con-tractuellement séparée de biens de Gérard Roberge, Florence Caron Sampson, épouse contractucllement séparée de biens de James Sampson, et Yolande Deslauriers Sampson, épouse séparée de biens de Christian Sampson, toutes marchandes publiques et dûment autorisées par leurs époux aux fins des présentes, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de balayeuses électriques, radios, appareils de télévision et accessoires électriques, sous le nom de \"Filtex du Québec Inc.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 100 actions communes de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-o C.E.CANTIN.(P.G.10485-55) Forêt Coulongc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un février 1955, constituant en corporation : Jacques Perron, avocat, Isabelle Beau-bien, sténographe, tous deux de Québec, et Robert Perron, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois sous toutes ses formes, sous le nom de \"Forêt Coulonge Inc.\", avec un capital total de $225,000, divisé en 2,500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10301-55) G.Bienvenue Limitée Avis est domié qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Germain Bienvenue, peintre, Florence Mallette, \" épouse commune en biens dudit Germain Bienvenue et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, de Montréal, et Maurice Mercure, avocat, de ville Mont-Royal, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre et faire affaires d'une manière générale comme entrepreneur en peinture, entrepreneur et constructeur d'immeubles, sous le nom de \"G.Bienvenue Limitée\", avec un eapital total de SIO.QOO, divisé en 20,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.(A.G.10423-55) Filtex du Québec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Lucie-Anne Dupuis Roberge, wife contractually separate as to property of Gérard Roberge, Florence Caron Sampson, wife contractually separate as to property of James Sampson, and Yolande Deslauriers Sampson, wife separate as to property of Christian Sampson, all public merchants and duly authorized by their husbands for the purposes herein, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in electric sweepers, radios, television apparatus, and electrical appliances, under the name of \"Filtex du Québec Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 100 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10485-55) Forêt Coulonge Inc.Notice is'hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of February, 1955, incorporating: Jacques Perron, advocate, Isabelle Beaubien, stenographer, both of Quebec, and Robert Perron, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business dealing in timber in all its forms, under the name of \"Forêt Coulonge Inc.\", with a total capital stock of $225,000, divided into 2,250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10301-55) < G.Bienvenue Limitée Notice is hereby'given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February 1955, incorporating: Germain Bienvenue, painter, Florence Mallette, wife common as to property of the said Germain Bienvenue and duly authorized by him for the purposes herein, of Montreal, Maurice Mercure, advocate! of the town of Mount Royal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on the business generally of painting contractor, building contractor, under the name of \"G.Bienvenue Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of a par value of $1 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1075 Le siège social de la compagnie sera à 7264, rue Champagneur, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.The head office of the corporation will be at 7264 Champagneur Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(P.G.10437-55) G.Gusson Ltée-Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Maurice Riel, de Laprairie, Lomer Gouin, de Ste-Adèle et Jean Geoffrion, d'Outremont, tous avocats, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de quincaillerie, matériaux de construction et accessoires d'entrepreneurs, sous le nom de \"G.Cusson Ltée-Ltd\", avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Delson, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G., 10422-55) General Textile Contractors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize février 1955, constituant en corporation: Lily Bercusson, ménagère, épouse séparée de biens de David Rosenberg et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, David Rosenberg, entrepreneur, tous deux de Montréal, et Issie Druckman, contremaître, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre et exercer le commerce comme entrepreneurs généraux pour la confection de vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"General Textile Contractors Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(A.G.10437-55) G.Gusson Ltée-Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Maurice Riel, of Laprairie, Lomer Gouin, of Ste.Adele, and Jean Geoffrion, of Outremont, all advocates, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware, buildg-ings materials and contractors supplies, under the name of \"G.Cusson Ltée-Ltd\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Delson, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10422-55) General Textile Contractors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been subscribed by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth of February, 1955, incorporating: Lily Bercusson, housewife, wife separate as to property of David Rosenberg, and duly authorized by him for the purposes of these presents, David Rosenberg, contractor, both of Montreal, and Issie Druckman, foreman, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on the business of general contractors of wearing apparel of all kinds, under the name of \"General Textile Contractors Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(P.G.10447-55) Delia Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Philip Meyerovitch, avocat et conseil en loi de la Reine, Perry Meyer, avocat, tous deux de Montréal, Hyman Solomon, avocat, de Ville Mont-Royal, et Morris Shuter, gérant de bureau, de Ville Saint-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Helia Realty Corporation\", avec un (A.G.10447-55) Helia Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Philip Meyerovitch, advocate and Queen's Counsel, Perry Meyer, advocate, both of Montreal, Hyman Solomon, advocate, of the town of Mount Royal, and Morris Shuter, office manager, of the town of St.Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Hclia Realty Corporation\", with a total capital 1076 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 capital total de 35,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10112-55) Herbert A.Watts (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour de février 1955, constituant en corporation: David Ross McMaster, Conseil en Loi de la Reine, Donald Edward MacKenzie, Austin Stuart Hyndman, avocats, Joseph Edward O'Brien et Murray Churchill Magor, étudiants en droit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de publicité, sous le nom de \"Herbert A.Watts (Quebec) Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 CE.CANTIN.(P.G.10425-55) Holiday Luggage Mfg.Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf février 1955, constituant en corporation: David Sanders, manufacturier, Lillian Lazare, secrétaire, fille majeure, et Netty Mol, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de valises, sacs, bourses, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, ceintures et nouveautés, sous le nom de \"Holiday Luggage Mfg.Co.Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10332-55) Hôtel Union Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Jacques Plante, comptable, Albert Lapolice, commis, Mildred Pease et Yvette Drolet, secrétaires, tous de Malartic, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Hôtel Union Limitée\", stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10112-55) Herbert A.Watts (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of February, 1955, incorporating: David Ross McMaster, Queen's Counsel, Donald Edward MacKenzie, Austin Stuart Hyndman, advocates, Joseph Edward O'Brien and Murray Churchill Magor, students-at-law, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an advertising company, under the name of \"Herbert A.Watts (Quebec) Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value of SI each and into 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10425-55) Holiday Luggage Mfg.Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of February, 1955, incorporating: David Sanders, manufacturer, Lillian Lazare, secretary, spinster, and Netty Mol, stenographer, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in luggage, bags, purses, wallets, change purses, key cases, belts and novelties, under 'the name of \"Holiday Luggage Mfg.Co.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of S100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10332-55) Hôtel Union Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: Jacques Plante, accountant, Albert Lapolice, clerk, Mildred Pease and Yvette Drolet, secretaries, all of Malartic, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on the business of holtel-keepers and restaurant-keepers, under the name of \"Hôtel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1077 avec un capital total de §40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.Union Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided info 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of Februarv, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(P.G.10129-55) International Dealers (A.G.10129-55) & Converters Inc.International Dealers & Converters Inc.Avis est donné\" qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-septième jour de février 1955, constituant en corporation: Harry J.Bilcfsky, de \"Montréal, Saul Lehrer, d'Outremont et Simon Steinberg de Ville Mont-Royal, tous marchands, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises sèches, chapeaux, casquettes, vêtements, garnitures pour tailleurs et tissus textiles, sous le nom de \"International Dealers & Converters Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et 2,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1955.L'Assistaitt-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10445-55) Lapoîmo Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Joseph-André-Edmond Poirier, Joseph-Gabriel-Alban Morin, entrepreneurs, de Saint-Cléophas, et Joseph-Camille Laflamme, entrepreneur, de Mont-Joli, tous dû district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Lapomo Construction Ltée\", avec un capital total de $40,000, Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: Harry J.Bilcfsky, of Montreal, Saul Lehrer, of Outremont, and Simon Steinberg, of the town of Mount Royal, all merchants, in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, furs, hats and caps, clothing, tailors' trimmings and textile fabrics, under the name of \"International Dealers & Converters Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and into 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(P.G.1048G-55) Jean-Marie Manilla Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Pothier Ferland, avocat, de Longueuil, Roger Craig, avocat,- d'Outremont, et Madelène Paradis, secrétaire, célibataire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateur, sous le nom de \"Jean-Marie Mantha Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions communes d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4, rue Notre-Dame, est, chambre 802, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(A.G.10486-55) Jean-Marie Mantha Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Pothier Ferland, advocate, of Longueuil, Roger Craig, advocate, of Outremont, and Madelène Paradis, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a restaurateur, under the name of \"Jean-Marie Mantha Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 4 Notre-Dame Street, East, Room 802, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10445-55) Lapomo Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Joseph-André-Edmond Poirier, Joseph-Gàbriel-Alban Morin, contractors of Saint-Cléophas, and Joseph-Camille Laflamme, contractor, of Mont-Joli, all of the judicial district of Rimouski, for the following purposes: To carry on the operations of a building company under the name of \"Lapomo Construction Ltée\", with a total capital stock of S40.000, 1078 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S avril 1955, Tome 87, N° 18 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera avenue Rioux, Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-o C.E.CANTIN.(P.G.10451-55) La Société de Chirurgie de Québec The Quebec Surgical Society Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Paul-A.Poliquin, Florian Trempe, James M.Elliott, Roland Cauchon, Jacques Turcot, Eucha-riste Samson, Gustave Auger, Jean-Marie I.eniicux, tous médecins, de Québec, Wilfrid Caron, médecin, de Cap Rouge, Hector Beaudet, médecin, de Charlesbourg, François Roy, Jean Sirois, médecins, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Grouper dans une association les médecins spécialisés dans tous les domaines de la chirurgie et promouvoir généralement leurs intérêts, sous le nom de \"La Société de Chirurgie de Québec \u2014 The Quebec Surgical Society\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10448-55) Le Centre des Loisirs d'Amos Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Falar-deau, Léandre Paré, industriels, et Gérard Martel, employé civil, tous d'Amos, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Établir un centre d'amusement et de récréation pour la jeunesse, sous le nom de \"Le Centre des Loisirs d'Amos Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $150,000.Le siège social de la corporation sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-û C.E.CANTIN.(P.G.10325-55) Le Pont de Glace de Bersimis Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en cor- f)oration sans capital-actions: Herman G.Ry-and, arpenteur, Donald Baker, industriel, tous divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Rioux Avenue, Mont-Joli, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10451-55) La Société de Chirurgie de Québec The Quebec Surgical Society Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Paul-A.Poliquin, Florian Trempe, James M.Elliott, Roland Cauchon, Jacques Turcot, Euchariste Samson, Gustave Auger, Jean-Marie Lcmicux, all physicians of Quebec, Wilfrid Caron, physician, of Cap Rouge, Hector Beaudct, physician, of Charlesbourg, François Roy, Jean Sirois, physicians, of Sillery, all of the judicial'district of Quebec, for the following purposes: To group together as an association, the physicians specialized in all fields of surgery, and further their interests generally, under the name of \"La Société de Chirurgie de Québec \u2014 The Quebec Surgical Society\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10448-55) Le Centre des Loisirs d'Amos Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard Falardeau, Léandre Paré, industrialist, and Gérard Martel, civil servant, all of Amos, judicial district of Abitibi, for the following purposes: Establish an amusement and recreational centre for young folks, under the name of \"Le Centre des Loisirs d'Amos Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $150,000.The head office of the corporation will be at Amos, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February 1955.C.E: CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10325-55) Le Pont de Glace de Bersimis Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Herman G.Ryland, surveyor, Donald Baker, industrialist, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1079 deux de Baie Comeau, et Gilles Trépanicr, ingénieur civil, de Hauterive, tous du district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Construire et entretenir un pont de glace sur la Rivière Bersimis, dans le comté de Saguenay, sous le nom de \"Le Pont de Glace de Bersimis Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20.000.Le siège social de la corporation sera à Baie Comeau, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10195-55) Les Industries Meunier Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Henri Gérin-Lajoie, Charles-Joseph Gé-linas, tous deux avocats et conseils en loi de la Reine, d'Outremont, et Pierre Bourque, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, d'articles et ameublements de maison; agir comme constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Les Industries Meunier Industries Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5225, rue St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10439-55) t Louise Lingerie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Adrien Duranlcau, comptable, René Cousineau, avocat, et Jacques Viger, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de lingerie, sous le nom de \"Louise Lingerie Inc.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.- L'Assistant-procureur général, 39524-Q C.E.CANTIN.(P.G.10419-55) Lucerne Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le.Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et both of Baie Comeau, and Gilles Trépanicr, civil engineer, of Hauterive, all of the judicial district of Saguenay, for the following purposes: To build and maintain an ice-bridge on the Bersimis River, in the county of Saguenay, under the name of \"Le Pont de Glace de Bersimis Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold its to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at Baie Comeau, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10195-55) Les Industries Meunier Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February 1955, incorporating: Henri Gérin-Lajoie, Charles-Joseph Gélinas, both advocates and Queen's Counsel, of Outremont, and Pierre Bourque, advocate of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and carry on the furniture business, deal in household furnishings and furniture; act as builders and contractors, under the name of \"Les Industries Meunier Industries Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 5225, St.Laurent Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10439-55) Louise Lingerie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Adrien Duranleau, accountant, René Cousineau, advocate, and Jacques Viger, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in lingerie, under the name of \"Louise Lingerie Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 300 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10419-55) Lucerne Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Shuster, all advocates, of the city and ju- 1080 GAZETTE OF F ICI ELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1965, Tome 87, N° 18 district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placement, sous le nom de \"Lucerne Holdings inc.\".avec un capital-actions divisé en 1.000 actions ordinaires sans valeur au pair.100 actions privilégiées catégorie A d'une valeur au pair de 810 chacune et 1.000 net ions privilégiées catégorie M d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur géi.rai.39524 C E.C vNTlN.(P.G.10094-55) Munfel Investment Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du dix-septième jour de février 1955, constituant en corporation: IL Cari Goldenberg, avocat et Conseil en Loi de la Reine.Moses Samuel Yelin.avocat, Esther Monson et Anna Mikula.secrétaire, filles majeures, usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Manfcl Investment Corporation Ltd.\", avec un capital total de S 10.000,divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Ix' siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général.39524 C.E.CANTIN.(P.G.10132-55) Mme I.Schacfcr Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Albert Schaefer, marchand.Ruth Schwartz Schaefer, ménagère, épouse contractuel lenient séparée de biens dudit Albert Schaefer, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Marcel Marier, avocat, tous de Drummond-ville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de textiles, marchandises sèches, ornements, fournitures de muisons, vêtements, bijoux, menus articles et articles en cuir, sous le nom de \"Mme I.Schaefer Ltée\", avec un capital total de $100,-000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 500 actions pri-valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera h Drum-mondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, .39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10420-55) North Star Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a dicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a building and investment corporation, under the name of \"Lucerne Holdings Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares of no par value, 100 Class A.preferred shares of the par value of 810 each and into 1.000 Class H preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN.39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10094-55) Munfel Investment Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have beenbeen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: II.Carl Goldenberg, advocate and Queen's Counsel, Moses Samuel Yelin, advocate, Esther Monson and Anna Mikula.secretaries, filles majeures usant de leurs droits, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment com-ny, under the name of \"Manfcl Investment Corporation Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and into 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of Februarv, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10132-55) Mme I.Schaefer Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February 1955, incorporating: Albert Schaefer, merchant, Ruth Schwartz Schaefer, housewife, wife contractually separate as to property of the said Albert Schaefer, and duly authorized by him for the purposes herein, and Marcel Marier, advocate, all of Drummondvil|e, judicial district of Arthabaska, for thefollo-wing purposes: To manufacture and deal in textile fabrics, dry goods, ornaments, household furnishings, wearing apparel, jewellery, notions, and leather goods, under the name of \"Mme I.Schaefer Ltée\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of a nominal value of $100 each and 500 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10420-55) North Star Invest incuts Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL CAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1081 été accordé par le Lieutenant -gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes eu date du dix-septième jour de février 1955, constituant en corporation : Davi I Goodman, avocat, de la ville de Hiinpsteid.Arthur (Jinniise, avocat, Yvonne Bélanger, secret;ire.fille majeure, de Montréal et Melvin Rothman, étnliautcn droit, de Westmount, t -us du district judiciaire de Montré d.pour les objets suivants: Exercer le commerce de placements sur immeubles, sous le nom de \"North Stir Investments Ltd.\", avec ii'î capital total de 810.000, divisé en 1,500 actions ordinaires de 810 chacune et 2,500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège soci I de la c impag de sera à Montréal, district judiciaire de Montré:!.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1955.L'A -i.-;t ant-preen re 11 r général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10328-55) O.Vallée Ltée * Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de.Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept lévrier 1955, constituant en corporation: Octave Vallée, industriel, Raymond Begin, ingénieur électricien, et René Boulet, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme constructeur et entrepreneur général, sous le nom de \"O.Vallée Ltée\", avec un capital total de 810.000.divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à (55, avenue Boisclerc, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39521-0 ('.E.CANTIN.(P.G.10507-55) Power Realty & Investment Corpn.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-quatrième jour de février 1955, constituant en corporation: Harold Lande, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Joseph S.Caplan, avocat et Sylvia Nitkin, sté: nographe, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agents d'immeubles, courtiers d'hypothèques, évaluatcurs et promoteurs d'entreprises immobilières, sous le nom de \"Power Realty & Investment Corpn.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 24,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-quatrième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN,.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the seventeenth day of February, 1955, incorporating: David Goodman, advocate, of the town of Hampstead, Arthur Garmaise, advocate, Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, and Melvin Rothman, law student, of Westmount.all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a real estate investment business, under the name of \"North Star Investments Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1.500 common shires of 810 each and into 2.500 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10328-55) O.Vallée Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters-patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February.1955, incorporating: Octave Vallée, industrialist.Raymond Begin, electrical engineer, and René Boulet, chartered accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as a bifil 1er and general contractor, under the name of \"O.Vallée Ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 05 Boisclerc Avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10507-55) Power Realty & Investment Corpn.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1955, incorporating: Harold Lande, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Joseph S.Caplan, advocate, and Sylvia Nitkin, stenographer, spinster of the full age of majority, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as real estate agents, mortgage brokers, real estate appraisers and promoters of real estate enterprises, under the name of \"Power Realty 6 Investment Corpn.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,000 common shares having a par value of $1 each and into 24,000 preferred shares having a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of Februarv, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General. 1082 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 (P.G.10304-55) P.Simard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Philippe Simard, agent, Albert Simard et Raymond Simard, ces deux derniers commis, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de toutes marchandises se rapportant aux pièces accessoires d'automobile ou toute autre chose ayant trait à l'automobile; de la ferronnerie, des articles de sjK)rt et de l'équipement de ferme, sous le nom de \"P.Simard Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 185, rue Dorchester, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10371-55) Quchank Uranium Copper Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: John Austin Murphy, avocat et conseil en loi de la Reine, Pierre Decary, avocat, Mildred Murphy, ménagère, fille majeure, Eleanor Hart, secrétaire, fille majeure, et Francis Joseph Dolan, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais, y compris des terrains et gisements d'huile et de gaz et les négocier, sous le nom de \"Quebank Uranium Copper Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de $3,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions d'une valeur au pair de SI chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10326-55) Radio-Telefilm Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept février 1955, constituant en corporation: Madeleine Baillargeon Saintonge, pu-blicistc, épouse contractuellemcnt séparée de biens de Jérôme Saintonge, et dûment autorisée (A.G.10304-55) P.Simard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: Philippe Simard, agent, Albert Simard, and Raymond Simard, the latter two, clerks, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes : To manufacture and deal in all merchandise pertaining to automobile repair parts and accessories or any other matter dealing with an automobile; in ironware, articles of sport and in farm equipment, under the name of \"P.Simard Inc.\", with a total stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 185, Dorchester Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10371-55) Quebank Uranium Copper Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: John Austin Murphy, advocate and Queen's Counsel, Pierre Decary, advocate, Mildred Murphy, housekeeper and an unmarried woman of the full age of majority Eleanor Hart, secretary and an unmarried woman of the full age of majorité and Francis Joseph Dolan, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals including oil and gas lands and deposits and deal with same, under the name of \"Quebank Uranium Copper Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 83,000,000, divided into 3,000,000 shares of a par value of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price to be paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10326-55) Radio-Telefilm Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February 1955, incorporating: Madeleine Baillargeon Saintonge, publicist, wife contractually separate as to property of Jérôme Saintonge, and duly authorized by the latter for QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1083 par ce dernier aux fins des présentes, Madeleine Besanceney, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, et Albert Morin, agent d'affaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter et administrer une ou des.agences de presse, de publicité et d'annonce, sous le nom de \"Radio-Telefilm Inc.\", avec un capital total de 82,000, divisé en 200 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-o C.E.CANTIN.(P.G.10470-55) Koger Laurin et Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Qué'bec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1955, constituant en corporation: Roger Laurin, marchand en gros, Léo Laurin, garagiste, et Robert Laurin, boucher-épicier, tous de Mont-Laurier, district judiciaire de Labclle, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce en gros et en détail de marchandises habituellement vendues dans une épicerie-boucherie, sous le nom de \"Roger Laurin & Fils Limitée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont-Laurier, district judiciaire de Labclle.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 .C.E.CANTIN.(P.G.10252-55) Roland Beaudry, Limitée Roland Beaudry, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize février 1955, constituant en corporation: Roland Beaudry, publiciste, Robert Clément, gérant, tous deux de Montréal, et Marie-Paule Blain, sténographe, fille majeure de Saint-Basile-le-Grand, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme agent de publicité, sous le nom de \"Roland Beaudry, Limitée \u2014 Roland Beaudry, Limited\", avec un capital total de $10,000, divisé ci 1,000 actions communes de $10 chacune.Le siège social de la compagnie, sera à 1980, rue Sherbrooke, ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.(P.G.10411-55) Seaway Storage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-septième jour de février 1955, constituant en corporation: Arthur Garmaise, David Good- the purposes herein, Madeleine Besanceney* secretary, fille majeure making use of her rights, and Albert Morin, business agent, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate and manage one or many press, publicity and advertising agencies, under the name of \"Radio-Telefilm Inc.\", with a total capital stock of 82,000, divided into 200 shares of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of February 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10170-55) Roger Laurin et Fils Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February 1955, incorporating: Roger Laurin, wholesale merchant, Léo Laurin, garage-keeper, and Robert Laurin.butcher-grocer, all of Mont Laurier, judicial district of Labelle, for the following puqioses: To manufacture and carry on a wholesale and retail business dealing in merchandise usually sold in a grocer and butcher shop, under the name of \"Roger Laurin & Fils Limitée\", with a toral capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Mont Laurier, judicial district of Labelle.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of February 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10252-55) Roland Beaudry, Limitée Roland Beaudry, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1955, incorporating: Roland Beaudry, publicist, Robert Clement, manager, both of Montreal, and Maric-Paule Blain, stenographer, spinster of Saint-Basile-le-Grand, all of the ju licial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of publicity agent, under the name of \"Roland Beaudry, Limitée \u2014 Roland Beaudry, Limited\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 1980 Sherbrooke Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10411-55) Seaway Storage Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of February, 1955, incorporating: Arthur Garmaise, David Goodman, advocates, Yvon- 1084 GAZETTE OF F ICI III.LE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1965, Tome 87, N° 18 man, avocats, Yvonne Bélanger, secrétaire, tons trois de .Montréal et Melviu Rothinau, étudiant, de Westmount.tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entreposage, emmagasinage et celui d'entrepôt, frigorifique, sous le nom de \"Seaway Storage Inc.\".avec un capital de $40.000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10457-55) South Shore Land Development Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de février 1955, constituant en corporation: Alexander Y.Bokor, administrateur, Léon Singer, mécanicien et Elizabeth Haez.secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"South Shore Land Development Company Limited\", avec un capita 1 total de 8L0.000.divisé en 100 actions ordinaires d'une vjleur au pair de $100 chacune et 100 actions \\ rlvilégiées «l'une valeur au pair de $10.) chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524 C.E.CANTIN.(P.G.10477-55) Sport Amusements Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la F/, i des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un féviier, 1955, constituant en corporation: Jean-Marie Chabot, épicier-boucher, Paul-Emile Gauthier, restaurateur, et Stella Chabot, ménagère, ép mse contractuelle-ment séparée de biens dudit Jean-Marie Chabot, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quilles en général, sous le nom de \"Sport Amusements Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5141, rue Notre-Dame ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un février 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-o C.E.CANTIN.(P.G.10438-55) The B.A.Colline Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de février 1955, consti- ne Bélanger, secretary, all three of Montreal, and Melvin Hothmau, student, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of warehousing, storage and cold storage, under the name of \"Seaway Storage Inc.\", with a capital stock of'$40,000, divided into 4,0 )0 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-o Deputy Attorney General.(A.G.10457-55) South Shore Land Development Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: Alexander V.Bokor, executive Léon Singer, mechanic, and Elizabeth Hacz, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"South Shore Land Development Company Limited\", with a total capital stock of 820,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 10.) preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.(A.G.10477-55) Sport Amusements Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Que' ec Companies' Act, -letters patent have I een issued by the Lieut.man t-G >verhbr of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of February, 1955, incorporating: Jean-Marie Chabot, grecer-butcher, Paul-Emile Gauthier, restaurant-keeper, an 1 Stella Chabot, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said Jean-Marie Chabot, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing generally in bowling, under the name of \"Sport Amusements Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 5141 Notre-Dame Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of February, 1955.C.E.CANTIN, 39524 Deputy Attorney General.(A.G.10438-55) The B.A.Gulline Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec ComjKiaies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1955, incorporating: QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, April ,W.19ÔÔ, Vol.87, No.13 1085 tuant en corporation: James Hilary Hume Robertson, avocat et Conseil en Loi «le la Reine, «le Montréal, James Brendan O'Connor, avocat, de Westmount et Rupert Charles Thomas Harris, avocat, «le Dorval, tous «lu district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le matériel nécessaire aux excursions «le chasse, pêche et campement, sous le nom «le \"The B.A.Gullinc Company\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 2,500 actions privilégiées «l'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 910 rue des Inspecteurs, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, ce vingt-deuxième jour «le février 1955.L'Assistant-procureur général.39524 C.E.CANTIN.(P.G.10400-55) The 186 St.Catherine Street West Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes en date du dix-septième jour «le février 1955, constituant en corporation: Joseph Baer.fourreur, Jack Liberman, manufacturier, Philip Shraguc Gn-ronce et Irwin Gliserman.avocats, tous des cité et district jueiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de propriétés immobilières, sous le nom «le \"The 486 St.Catherine Street West Corp.\".avec un capital total «le 8125.000.divisé en 50 acti >us catégorie \"A\", «l'une valeur au pair «le $10 ) chacune, 200 actions, catégorie \"B\", d'une valeur ai pair «le 810!) chacune et 1,000 actions privih',gis salariés régis par\", le tout apparaissant à la fin du paragraphe \"a\" de l'article IV.sont biffés.4° Le paragraphe \"c\" de l'article IV est biffé.5° Les mots \"Mécaniciens en tuyauterie, poseurs d'appareils de chauffage\" et suivants, apparaissant au paragraphe \" Comité peut exiger, à titre d'honoraire, une somme n'excédant pas 82.00 pour l'examen d'un ouvrier qualifié et 81.00 pour i'exemen d'un apprenti.\" Le Sous-ministre du Travail.G ÊRARD TREM II LAVAI inist ère du Travail.Québec, le 2 avril 1955.39564-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire de l'industrie de la chausure lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en conseil les modifications suivantes au décret numéro 3003 du 31 juillet 1946, relatif à l'industrie de la chaussure dans la province de Québec: 1° Les mots suivants seront ajoutés à la fin de l'opération 506-2, après les mots \"poinçonner l'œil d'oiseau\": \"peinturer les fonds (507-3À).\" 2° L'opération 507-3A sera ajoutée: \"507-3A.\u2014 Peinturer les fonds sablés ou non sablés.\" \u20223° L'opération 520-5A sera remplacée par la suivante: \"520-5A.\u2014 Pulvériser, vernir avec vernis incolore ou vernis noir; poser l'antique.\" 4° L'opération 520-4 sera remplacée par la suivante: \"520-4.\u2014 Poser la teinture (dope) pour uniformiser la couleur du cuir; vernir avec vernis de couleur (excepté le vernis noir\u2014520-5A).\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formider.LeSous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 2 avril 1955.39504-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformé ment aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux établissements commerciaux de la ville de St-Féli-cien et un rayon de cinq (5) milles de ses limites, rendue obligatoire par le décret numéro 1297 du Certificate of competency: Pursuant to section 25 of the Act, the Parity Committee renders the certificate of competency obligatory in the entire territorial jurisdiction of the decree No.254 of March 5, 1953, and amendments, for all employees governed by the said decree.For the purpose of determining the qualification or competency of the employees and of issuing the said certificates of competency, the Parity Committee forms two boards of examiners composed of two members each.On board shall be composed of two barbers for the examination of barbers and one board shall be composed of two male or female hairdressers for the examination of a hairdressers.The quorum of these boards shall be two members.The Committee may charge a fee not exceeding 82.00 for the examination of a skilled worker, and 81.00 for the examination of an apprentice.\" GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec, April 2, 1955.39564-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of the Shoe Industry has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the decree No.3003 of July 31, 1946, relating to the shoe industry in the province of Quebec: 1.The following words will be added at the end of operation 506-2, after the words \"punching bird's eye\": \"painting bottoms (507-3A).\" 2.The following operation 507-3A will be added : \"507-3A.\u2014 Painting bottoms, buffed or un-buffed.\" 3.Operation 520-5A will be replaced by the following: \"520-5A.\u2014 Spraying, dressing, with colorless or black varnish; setting antique.\" 4° Operation 520-4 will be replaced by the following: \"520-4.\u2014 Dyeing or \"doping\" to make the colour of the leather uniform; dressing with colour varnish (except black varnish \u2014 520-5A.) \" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quelle Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, April 2th, 1955.39564-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the commercial establishment of the town of St.Félicien and a radius of five (5) miles from its limits, rendered obligatory by the decree No.1297 of November QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April '2nd, 1955, Vol.87, No.13 1119 26 novembre 1953, lui ont présenté une requête ù l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieu tenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret : 1° Le mot \"restaurant\" apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article I sera biffé.2° Le paragraphe \"//' de l'article I sera biffé.3° Le paragraphe \"/\" de l'article I sera biffé.4° Les mots \"au restaurants\"«apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article II seront biffés.5° Le paragraphe \"6\" de l'article III sera remplacé par le suivant : \"b) La semaine régulière de travail est de cinquante-trois (53) heures pour les salariés des deux sexes, reparties de la façon suivante: 1° De 8,30 a.m.à 6.00 p.m.les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.2.De 8.30 a.m.à 9.00 p.m.le samedi et la veille des fêtes chômées, les trois (3) jours ouvrables précédent Noël.3° Tout salarié a droit à une heure (1) pour le repas du midi et, les jours oû il doit retourner au travail le soir, à une heure (1) pour le repas du soir.\" 6° Les mots \"la fête de Dollard\" seront ajoutés après le mot \"L'Ascension\" apparaissant au deuxième alinéa du paragraphe \"«\" de l'article IV.7° Le paragraphe \"b\" de l'article IV sera remplacé par le suivant: \"b) Le salaire des salarié's soumis à la semaine de cinquante-trois (53) heures, ne doit pas être diminué à cause des fêtes chômées.\" 8° Le paragraphe \"c\" de l'article VI-A sera biffé.9° Le paragraphe \"6\" de l'article VII sera remplacé par le suivant: \"b) Les salariés rémunérés sur une base de salaire et de commission ou de commission seulement ont droit à des vacances payées en prenant comme base de rémunération le salaire gagné.\" 10° Le paragraphe \"o\" de l'article VII sera biffé.11° L'article XI sera biffé.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 2 avril 1955.39564-0 26th, 1953, have petitioned him to submit tô the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: 1.The words \"groceries-restaurants\" mentioned in subsection \"a\" of section I will be deleted.2.Subsection \"b\" of section I will be deleted.3.Subsection \"/\" of section I will be deleted.4.The words \"ou restaurants\" mentioned in subsection \"a\" (French version) of section II will be deleted.5.Subsection \"b\" of section III will be replaced by the following: \"b) The standard work week consists of fifty-three (53) hours for male and female employees.These hours of work arc distributed as follows: 1.From S.30 a.m.to (5.00 p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday.Thursday and Friday.2.From 8.30 a.m.to 9.00 p.m.on Saturday and holiday eves and the three (3) working days preceding Christmas.3.Every employee is entited to one (1) hour for the noon meal and to one (1) hour for the evening meal when work is to be performed by the employee in the evening.\" 6.The words \"Dollard Day\" will be added after the words \"Ascension Day\" mentioned in the second paragraph of subsection \"a\" of section IV.7.Subsection \"6\" of section IV will be replaced by the following: \"b) The wages of employees subject to the 53-hour week shall not be affected by holidays.\" 8.Subsection \"e\" of section VI-A will be deleted.9.Subsection \"6\" of section VII will be replaced by the following: \"6) Employees paid on a salary and commission basis, or on a commission basis alone, are entitled to a vacation with pay based on the wages earned.\" 10.Subsection \"c\" of section VII will be deleted.11.Section.XI will be deleted.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, April 2nd, 1955.39564-o Lettres patentes ERRATUM Dans l'avis publié dans la Gazette officielle de Québec du 26 mars 1955, page 999, le nom de la compagnie \"Gardicore Uranium Corporation\" doit se lire comme suit: \"Cardicore Uranium Corporation\" > 39524-0 (Sec.P.201-55) Belair Insurance Company Avis est par les présentes donné qu'en vertu des articles 2 et suivants de la Loi des assurances de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres Letters Patent ERRATUM In this notice published in the Quebec Official Gazette.March 26th, 1955, page 999, the name of the company \"Gardicore Uranium Corporation\" must read as follows: \"Cardicore Uranium Corporation\".39524-0 (P.Sec.201-55) Bclair Insurance Company Notice is hereby given that under sections 2 and following of the Quebec Insurance Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, dated 1120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 13 patentes en date du quatorzième jour de mars 1955, constituant en corporation: Paul Meriot, administrateur.Emile Edgar Lanthier, administrateur, Abe Anderson, commerçant, Jean-Marie Goulet, administrateur, Samuel Kantor, administrateur, Arsène Ambroisc Pigeon, commerçant, William Howard Wert, comptable agréé, pour les objets suivants: Transiger les groupes d'assurance et de réassurance suivants: contre les accidents, d'automobiles, «l'aviation, contre le vol avec ou sans effraction, de crédit, contre les explosions, contre le feu, contre le faux, de garantie, contre la grêle, industrielle, de navigation intérieure, des transports intérieurs, sur le bétail, maritime océanique, contre le bris de glace (plate-glass), contre la maladie, contre les défectuosités d'extincteurs automatiques, sur les chaudières à vapeur, contre les cyclones, contre l'intempérie, et tout autre groupe d'assurance et de réassurance, excepté l'assurance-vie; Réaliser toutes opérations et conclure tous contrats nécessaires ou utiles à la poursuite de ses affaires: Le tout dans les limites fixées par la Loi des assurances de Québec, sous le nom de \"Belair Insurance Company\", avec un capital de cinq cent mille dollars (§500,000.) divisé en cinq mille (5,000) actions ordinaires d'une valeur au pair de cent dollars (SI00.) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera à Montréal, dans le district de Montréal.Lesdites lettres patentes seront en vigueur à compter de la date de l'émission d'un permis à la compagnie en vertu de la Loi des assurances de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de mars 1955.L'Assistant-procureur général, 39524-0 C.E.CANTIN.Liquidation, avis de: the fourteenth day of March 1955, incorporating: Paid Meriot, executive, Emile Edgar Lanthier, executive, Abe Anderson, tradesman, Jean-Marie Goulet, executive, Samuel Kantor, executive, Arsène Ambroise Pigeon, tradesman, William Howard Wert, chartered accountant, for the following purposes: To transact the business of insurance and reinsurance of the following classes: accident, automobile, aviation, larceny, housebreaking or burglary, credit, explosion, fire, forgery, guarantee, hail, industrial, inland marine, inland transportation, livestock, ocean marine, plate glass, sickness, sprinkler leakage, steam boiler, tornado, weather, and all other classes of insurance and reinsurance, except life insurance ; To carry out any operations and make any other contracts necessary for the conduct of its business; The whole within the scope of the limits fixed by the Quebec Insurance Act, under the name of \"Hetair Insurance Company\", with a capital stock of five hundred thousand dollars (S500.000.) divided into five thousand (5,000) ordinarv shares of a par value of one hundred dollars (SI00.) each.The head office of the company will be at Montreal, in the district of Montreal.The letters patent shall come into force as from the date of issue of a license to the company under the Quebec Insurance Act.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of March 1955.C.E.CANTIN, 39524-0 Deputy Attorney General.Winding up Notices: Avis est donné que, lors d'une assemblée générale du syndicat coopératif \"Coopérative Christ-Roi\", tenue à Lachine, le quatorze décembre 1954, une résolution a été adoptée, à l'effet que les affaires de ladite société soient liquidées volontairement et «pic celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi «les syndicats coopératifs de Québec et de la Loi «le la liquidation volontaire «les compagnies à fonds social, et que MM.Bernard Vallée, Roger Legault et Marcel Marleau ont été nommés liquidateurs.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-trois mars 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 39543-Q JEAN BRUCHÉSI.Ministère des P'inances Assurances Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que \"La Compagnie «l'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal \u2014 Montreal Automobilists' Club Insurance Company\", constituée en corporation par lettres patentes en conformité des dispositions des articles 2 et suivants de la Loi des assurances (chapitre 299, S.R.Q.1941) et Notice is given that at a general meeting of the Cooperative Syndicate \"Coopérative Christ-Roi\", held at Lachine, December fourteenth 1954, a resolution has been adopted to the effect that the affairs of the said association shall be voluntarily wound-up and that the latter shall be dissolved, in accordance with the provisions of the Cooperative Syndicates Act and the Winding-up Act, and that Messrs.Bernard Vallée, Roger Legault and Marcel Marleau have been appointed liquidators.(iiven at the office of the Provincial Secretary, the twenty-third day t>f March 1955.JEAN BRUCHÉSI, 39543 Under Secretary of the Province.Department of Finance Insurances Notice of issue of license and certificate of registration Notice is hereby given that \"La Compagnie d'Assurance du Club des Automobilistes de Montréal \u2014 Montreal Automobilists' Club Insurance Company\", incorporated by letters patent pursuant to the provisions of sections 2 and following of the Quebec Insurance Act (chapter 299, R.S.Q.1941) and registered under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1121 enregistrée sous le numéro 557, a obtenu le permis et certificat d'enregistrement numéro 1899 qui l'autorise, à compter du 22 mars 1955, à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Accident; Automobile.Le siège social de la compagnie est situé à 9, rue Laurier est, Montréal, province de Québec.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 23 mars 1955.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRAXCE, 39510-12-2-o Surintendant des assurances.number 557, bas obtained the license and certificate of registration number 1899 authorizing it, as from the 22nd of March 1955, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Accident; Automobile.The head office of the company is situate at 9 Laurier Street east, Montreal, province of Quebec.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 23rd of March 1955.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 39510-12-2-o Superintendent of Insurance.Avis de changement de nom Avis est donné par les présentes que \"Christiania Almindeligc Forsikrings-Aktieselskap Sto-rebrand\", constituée en corporation conformément aux lois de la Norvège, et enregistrée dans la province sous le nom anglais de \"Christiania General Insurance Company Limited Store-brand\" sous le numéro 519.a changé de nom anglais et est maintenant enregistrée sous le nom de \"Christiania Almindeligc Forsikrings-Aktieselskap Storcbrand\", et en anglais \"Sto-rebrand Insurance Company Limited\".Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 29 mars 1955.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 39576-0 Surintendant des assurances.Notice of change of name Notice is hereby given that \"Christiania Almindeligc Forsikrings-Aktieselskap Storcbrand\", incorporated under the laws of Norway, and registered in this province under the English name of \"Christiania General Insurance Company Limited Storcbrand\" under number 519, has changed its English name and is now registered under the name of \"Christiania Almindeligc Forsikrings-Aktieselskap Storebrand\", and in English \"Storebrand Insurance Company Limited\".Given at the office of the Insurance Branch.Department of Finance, the 29th of March 1955.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 39576-0 Superintendent of Insurance.Nomination Appointment Il a plu à son Honneur le Lieutcnant-gouver- His Honour, the Lieutenant-Governor, with neur, de l'avis et du consentement du Conseil the advice and consent of the Executive Council, Exécutif, et par commission, de faire la nomi- and by Commission, has been pleased to make nation suivante: the following appointment: Québec, le 17 décembre 1954.M.Joachim Grenier, avocat, conseil en loi de la Reine, et président de la Commission des accidents du travail de Québec: nommé, à compter du 1er janvier 1955, juge de district avec juridiction dans toute la province mais particulièrement dans le district judiciaire de Québec, et pour agir, dans la province, selon l'article 21 de la loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 29, comme magistrat de district en ce qui concerne les juridictions attribuées par les lois du Parlement du Canada aux magistrats de district, que ces juridictions leur soient attribuées sous le titre de \"magistrat\" ou sous celui de \"magistrat de district\", avec résidence officielle dans la cité de Québec ou ses environs.39524-0 Quebec, December 17, 1954.Mr.Joachim Grenier, advocate, Queen's Counsel, and President of the Quebec Workmen's Compensation Commission: appointed, from January 1st, 1955, District Judge, with jurisdiction within the whole of the Province, but especially within the judicial district of Quebec, ami to operate, within the Province, according to Article 21 of the Act 1-2 Elizabeth II, chapter 2.9, as District Magistrate with respect to the jurisdictions conferred by the acts of the Parliament of Canada upon district magistrates, whether such jurisdictions be conferred under the title of \"Magistrate\" or that of \"district magistrate\", with official residence in the City of Quebec or its surroundings.39524 ' Ordre de Cour Rule of Court Canada, Province de Québec, district de St-François, N° 12,997, Arthur Salois, demandeur; vs Roger Vaillancourt, et Gérard Vaillancourt, défendeurs et Joseph Vaillancourt, tiers-saisi.Avis est donné à tous les créanciers des défendeurs ci-dessus mentionnés que par jugement de l'Honorable Juge Mitchell rendu le 15 mars Canada, Province of Quebec, District of St.Francis, No.12,997, Arthur Salois, plaintiff; vs Roger Vaillancourt and Gérard Vaillancourt, defendants and Joseph Vaillancourt, garnishe.Notice is given to all creditors of the above mentioned defendants that by judgment of the Honourable Justice Mitchell, rendered on March 1122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 18 1955, les défendeurs ont été déclarés en déconfiture, et qu'appel leur est fait de produire leurs réclamations dans les quinze jours de la date de la première insertion du présent avis, au greffe de la Cour Supérieure dans la cause ci-dessus mentionnée, pour être colloques suivant la loi conformément aux articles 673 et 674 de Procédure Civile.Le Protonotaire de la Cour Supérieure, Sherbrooke, Que., 39497-12-2-Q ALBERT DÉSILETS, c.r., Proclamation Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.].ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront, concerner.Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur l À TTENDU que l'ho-général, 1 norable Ministre des C.E.Cantin.\\ terres & forêts de Notre (.province de Québec a fait préparer, sous sa direction, conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi 21 George V, chapitre 104, des plans et livres de renvoi revisés: 1° d'une partie de la paroisse de Ste-Anne-de-la-Pocatière, division d'enregistrement fie Kamouraska; 2° du village de Princcville, division d'enregistrement d'Arthabaska; Attendu que ces plans et livres de renvoi révisés font maintenant partie des archives du département des terres & forêts, et que des copies exactes ont été déposées aux bureaux des divisions d'enregistrement de Kamouraska et d'Arthabaska; * A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans l'arrêté en conseil N° 231, en date du 2 mars 1955, et conformément aux dispositions des articles 2174 et 2174A du Code civil, et du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi 21 George V, chapitre 104.Nous donnons avis du dépôt de ces plans et livres de renvoi révisés mentionnés ci-dessus aux bureaux des divisions d'enregistrement qu'ils appartiennent, lesquels sont désignés ci-dessus, et Nous fixons à la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le jour auquel les dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi modifiant les articles 2174A et 2175 du Code civil (21 George V, chapitre 104), deviendront en vigueur relativement à cette partie de la paroisse de Stc-Anne-de-la-Pocatière et du village de Princeville, divisions «l'enregistrement de Kamouraska et d'Arthabaska; et Nous invitons toute personne intéressée, à peine de perdre la priorité conférée par la loi, à renouveler, dans l'année qui suit la date fixée ci-dessus, toutes les hypothèques affectant parti- 15th, 1955, the defendants have been declared insolvent and that an appeal is made to produce their claims within fifteen days from the date of the first insertion of the present notice to the office of the Superior Court, in the case hereinabove mentioned, to be collicatcd according to the law, articles 673 and 674 of the Code of Civil Procedure.ALBERT DÉSILETS, Q.C., Prothonotary of the Superior Court, 39497-12-2-o Sherbrooke, Que.Proclamation Canada.Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, / \\\\THEREAS the Honou-Deputy Attorney ) W rable the Minister of General.\\ Lands and Forests of Our t.Province has caused to be prepared under his supervision, in conformity with sub-paragraph a of paragraph 1 of section 3 of the Act 21 George V, chapter 104, revised plans and books of reference: 1, of one part of the parish of Ste-Anne-de-la-Pocatière.registration division of Kamouraska; 2.of the village of Princeville, registration division of Arthabaska; Whereas these revised plans and books of reference now form part of the archives of the Department of Lands and Forests, and that exact copies have been deposited with the offices of the Registration Divisions of Kamouraska and Arthabaska; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in Order in Council No.231, dated March 2nd, 1955, and according to provisions of sections 2174 and 2174A of the Civil Code, and of sub-paragraph a of paragraph 1 of section 3 of the Act 21 George V, chapter 104.We give notice of the deposit of these revised plans and books of reference mentioned hereinabove with the offices of the registration divisions to which they belong, which are hereinabove designated, and We fix the date of the publication of the present proclamation in the Quebec Official Gazette, the day upon which the provisions of sub-paragraph c of paragraph 1 of section 3 of the Act amending articles 2174A and 2175 of the Civil Code (21 George V, chapter 104), shall enter into force relative to that part of the parish of Ste-Anne-de-la-Pocatière and of the village of Princeville, registration divisions of Kamouraska and of Arthabaska; and We invite any interested party, under penalty of losing the priority conferred by Law, to i onew, within the year following the date fixed hereinabove, all the hypothecs particularly affecting QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol 87, No.13 1123 culièrement aucun des lots aux plans et livres de renvoi et non comprises les hypothèques affectant tout le terrain subdivisé.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P.LL.D., D.D.S., -L.D.S.Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de mars en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatrième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 39547-0 JEAN BRUCHÉSI.Sièges sociaux Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.Avis d'adresse du bureau principal Avis est.donné que la compagnie \"Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.\", a établi son bureau principal au N° 190 est, Blvd Crémazie, Montréal.Daté à Montréal, ce 23e jour de mars 1955.Le Secrétaire, 39537-0 J.ALFRED ÉTHIER.Appartement Longpré Ltée Avis d'adresse du bureau principal Avis est donné cpie la compagnie \"Appartement Longpré Ltée\", a établi son bureau principal au N° 190 est, Blvd Crémazie, Montréal.Daté à Montréal, ce 23e jour de mars 1955.Le Secrétaire, 39538-0 J.ALFRED ÉTHIER.(P.G.13104-54) St-Martin Die Casting Co.Ltd Règlement N° 25 Attendu que les ateliers et l'administration de la \"Compagnie St-Martin Die Casting Co., ayant son bureau-chef à St-Martin comté de Laval, sont maintenant déménagés à St-Marc des Carrières, comté de Portneuf.Attendu qu'il est opportun de changer le bureau-chef de ladite compagnie et qu'une séance spéciale des directeurs a été convoquée à cette fin.En conséquence, il est statuée et résolu à l'unanimité que le présent règlement N° 25 soit adopté et soumis aux actionnaires aux fins d'établir désormais le bureau-chef de la compagnie à St-Marc des Carrières, comté de Portneuf, district de Québec, et que les avis nécessaires any of the lots on the plans and books of reference and not including the hypothecs affecting all the subdivided land.Ok all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at our Government House in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this twenty-eighth day of March in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty-five and in the fourth year of Our Reign.Bv command, JEAN BRUCHÉSI, 39547 Under Secretary of the Province.Head Offices Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.Notice of head office address Notice is hereby given that the company \"Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.\", has established its head office at No.190 East Crémazie Boulevard, Montreal.Dated at Montreal, this 23rd day of March, 1955.J.ALFRED ÉTHIER, 39537 Secretary.Appartement Longpré Ltée Notice of head office address Notice is hereby given that the company \"Appartement Longpré Ltée\" has established its head office at No.190 East, Crémazie Boulevard, Montreal.Dated at Montreal, this 23rd day of March, 1955.J.ALFRED ÉTHIER, 39538 Secretary.(A.G.13104-54) St-Martin Die Casting Co.Ltd By-law No.25 Whereas the workshops and the management of the company \"St-Martin Die Casting Co., having its head office at St-Martin county of-Laval, are now moved to St-Marc des Carrières, county of Portneuf.Whereas it is opportune to change the head office of the said company and that a special meeting of the directors has been convocatcd for this purpose: Therefore, it is enacted and resolved unanimously that the present by-law No.25 be adopted and submitted to the shareholders for the purpose of hereinafter establishing the head office of the company at St-Marc des Carrières, county of Portneuf, district of Quebec, and that the 1124 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 18 soient donnés dans la Gazette officielle de Québec necessary notices be given to the Quebec Officia en conformité avec l'article 84 de la Loi des Gazette, pursuant to with article 84, of the compagnies.Quebec Companies' Act.Vraie copie 39545-0 Le Secrétaire-trésorier, ROLAND BERTRAND.True copy 39545 ROLAND BERTRAND, Secretary-Treasu rer.Extrait des minutes d'une assemblée des directeurs de \"Béchard Frères, Ltée\", tenue le quinzième jour du mois de février mil neuf cent cinquante-cinq (15 février 1955).Le Secrétaire soumet à l'assemblée que, par suite de la vente de notre commerce de détail, nous ne serons plus cbez-nous au numéro 1950 est de la rue Ontario, et il estime qu'il serait désirable de transporter notre Bureau-Chef au numéro 1053 de la rue l'arc Lafontaine, à Montréal.Les directeurs sont unanimes à approuver ce changement et le secrétaire est chargé de faire le nécessaire pour mettre tous les intéressés au courant de ce changement et notamment les gouvernements Fédéral et Provincial.Extrait certifié conforme, Montmagny, le 24 février 1955.Le Secrétaire, ANDRÉ BÉCHARD.La résolution relatée ci-haut a été dûment ratifiée par les Actionnaires, représentant 141 actions sur 145, à une assemblée générale spéciale tenue le 15 février 1955.(Sceau) Ix! Secrétaire, 39535-0 ANDRÉ BÉCHARD.Herbert A.Watts (Quehec) Limited Avis est donné que la compagnie \"Herbert A.Watts (Quebec) Limited\", incorporée par lettres patentes émises en vertu des dispositions «le la première partie de la Loi «les Compagnies de Québec, le quatre février 1955 et ayant son bureau principal dans la ville «le Montréal, a établi son bureau au numéro 2123 «le l'avenue Hingston.Daté à Montréal, ce 28c jour «lu mois de février 1955.Le Présulent, 39530-o (Signé): H.A.WATTS.(P.G.10228-55) Mellow Light Manufacturing, Limited Avis «l'adresse Extrait «les minutes «l'une assemblée des directeurs de \"Mellow Light Manufacturing, Limited\", tenue à Montréal, le Sème jour «le mars 1955: \"Il est unanimement résolu que: Le siège social de la compagnie sera à la suite 25, au numéro 204 ouest, de la rue Notre-Dame, à Montréal.\" Montréal, le 15 mars 1955.Certifié conforme.(Sceau) Le Secrétaire, 39502-o FRANÇOIS MOREL.Extract of the Minutes of a meeting of the directors of \"Béchard Frères, Ltée\", held on the fifteenth «lay of the month «>f February, one thousand nine hundred ami fiftv-five (February 15th, 1955).The Secretary submits to the Meeting that, following the sale of our retail business, we shall no longer be listed at number 1950 Ontario Street, East and he deems it advisable to transfer our Head Office to number 1053 Pare Lafontaine Street, in Montreal.The Directors are unanimous in approving this change ami the Secretary is charged to advise all interested parties of this change and especially the Federal and Provincial Governments.Certified true extract, Montmagny, Februarv 24th, 1955.ANDRÉ BÉCHARD, Secretary.The above stated resolution has been duly ratifietl by the shareholders, representing 141 shares on 145.at a special general meeting held on February 15th, 1955.(Sc_il) ANDRÉ BÉCHARD, 39535 Secretary.Herbert A.Watts (Quebec) Limited Notice is hereby given that \"Herbert A.Watts (Quebec) Limited\", incorporate«l by letters patent issued under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 4th day of February, 1955 and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 2123 Kingston Avenue.Dated at Montreal, this 28th day of February, 1955.(Signed): II.A.WATTS, 39536-0 President.(A.G.10228-55) Mellow Light Manufacturing, Limited Notice of location Excerpt from minutes of a meeting of «lirectors of \"Mellow Light Manufacturing, Limited\", held at Montreal, the 8th day of March 1955: \"It is unanimously resolved that: the head office of the company shall be locate*! at Suite 25, 204 Notre Dame Street, West, at Montreal.\" Montreal, March 15, 1955.True copy.(Seal) FRANÇOIS MOREL, 39562 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1125 Soumissions Province de Québec Les Commissaires d'Ecoles pour la Municipalité de Wexdover & Simpson (Comté de Dmmmond) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné.L.-S.loyal, N.P., secrétaire-trésorier, St-Cyrille-de-Wendover, comté de Drummond, jusqu'à 7 heures p.m., mardi, le 19 avril 1955 pour l'achat de S40.000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de Wendover & Simpson, comté de Drummond, datées du 1er mai 1955 et remboursables par séries du 1er mai 1956 au 1er mai 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à Ax/l°/o P!ir année payable semi-annucllement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 14 février 1955\u2014Construction d'une école dans l'arrondissement N° 12.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $40,000.00 \u2014 15 ans.Année Capital 1er mai 1950.xS7.000.00 1er mai 1957.x 7.500.00 1er mai 1958.x 7,500.00 1er mai 1959.1,000.00 1er mai I960.1,000.00 1er mai 1961 .1,500.00 1er mai 1962.1.500.00 1er mai 1963.1.500.00 1er mai 1964.1,500.00 1er mai 1965.1,500.00 1er mai 1966.1,500.00 1er mai 1967.1.500.00 lermailOOS.1,500.00 1er mai 1969.2.000.00 1er mai 1970 .2,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 820,820, accorde par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de 80,940 chacun, de 1956 à 1958 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Drummondville, comté de Drummond.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure «l'emprunt à Montréal, à Québec ou à Drummondville, comté de Drummond.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montsnt de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Tenders Province of Quebec \u2022 The School Commissioners for the Municipality of Wendover & Simpson (County of Drummond) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned L.-S.loyal.N.P.Secretary Treasurer, St.Cyrille de Wendover, County of Drummond, until 7 o'clock p.m., Tuesday, April 19,1955for the purchase of an issue of 840.000.00 of bonds of the School Commissioners for the Municipality of Wendover & Simpson.County of Drummond.dated May 1st.1955 and redeemable serially from May 1st., 1956 to May 1st., 1970 inclusively, with interest at a rate of not less than 3% or more than per annum, payable .semi-annually on May 1st., and November 1st., of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution dated February 14, 1955 \u2014 Erection of school in Ward 12.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from May 1st.1955.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 S.'t0,000.00 - 15 years Year Capital May 1st, 1956 .xS7.000.00 May 1st.1957 .x 7.500.00 May 1st, 1958 .x 7.500.00 May 1st.1959 .1,000.00 May 1st, 1960.1.000.00 May 1st.1961 .1.500.00 May 1st.1902 .1.500.00 May 1st.1963 .1.500.00 May 1st, 1964 .1.500.00 May 1st.1965.1.500.00 May 1st.1966 .1.500.00 May 1st, 1967 .1.500.00 May 1st.1968 .1,500.00 May 1st.1969 .2.000.00 May 1st.1970 .2.000.00 The Jctlers x indicate the years during which annual payments of a total amount of 820,820 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of $6,940 each, from 1956 to 195S inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Drummondville, County of Drummond.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or Drummondville, county of Drummond.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender. 1126 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 18 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 19 avril 1955, à 7 heures p.m., en la salle publique, St-Cyrillc-de-Wendover, comté de Drummond.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Cyrille-de-Wendover, (Comté de Drummond), ce 29 mars 1955.Le Secrétaire-trésorier, L.-S.JOYAL, N.P.St-C yri I le-dc-Wendover, (Comté de Drummond), P.Q.- 39575-0 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la Municipalité de l'Ile Bizard (Comté de Jacques-Cartier) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, André Boileau, secrétaire-trésorier, 530 Chemin Cherrier, Ile Bizard, Cté Jacques-Cartier, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi, le 20 avril 1955, pour l'achat de $165,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de l'Ile Bizard, comté de Jacques-Cartier, datées du 1er avril 1955 et remboursables par séries du 1er avril 1956 au 1er avril 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à i}/2% par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 10 mai 1954, telle que modifiée \u2014 Construction des écoles Nos 1 et 2.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement'\u2014 $166,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1956.xS34,000.00 1er avril 1957.x 21,000.00 1er avril 1958.x 22,000.00 1er avril 1959.3.500.00 1er avril 1960.3,500.00 1er avril 1961.4,000.00 1er avril 1962.4,000.00 1er avril 1963 .4,000.00 1er avril 1964.4,500.00 1er avril 1965.4,500.00 1er avril 1966.5,000.00 1er avril 1967 .5.000.00 1er avril 196S.5,000.00 1er avril 1969 .5,500.00 1er avril 1970.5,500.00 1er avril 1971.6,000.00 1er avril 1972.6,000.00 1er avril 1973.6,500.00 1er avril 1974.6,500.00 1er avril 1975.9,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total deS72,900.00 accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements dont le premier de 834.100.00 et les deux autres de 819,400.00 chacun, de 1956 à 1958 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, comté de Jacques-Cartier.The tenders will be opened and considered at meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, April 19, 1955, at 7 o'clock p.m., at the Public Hall, St.Cyrille de Wendover, County of Drummond.The School Commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.St.Cyrille de Wendover, (Countv of Drummond), this March 29, 1955.L.-S.JOYAL, N.P., Secretary-Treasurer.St.Cyrille de Wendover, (County of Drummond) P.Q.39575 - Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of l'Ile Bizard (County of Jacques-Cartier) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned André Boileau, Secretary-Treasurer, 530 Cherrier Road, He Bizard, Cty Jacques-Cartier, until 8 o'clock p.m., Wednesday, April 20, 1955 for the purchase of an issue of $165,000.00 of bonds of the Commissioners for the municipality of He Bizard, County of Jacques-Cartier, dated April 1st, 1955 and redeemable serially from April 1st, 1956 to April 1st, 1975 inclusively, with interest at a rate of not less than 3% or more than 4j^% per annum, payable semi-annually on April 1st, and October 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Résolu lion dated May 10, 1954, as amended \u2014 Erection of Schools No.1 and 2.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from May 1st, 1955.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $105,000.00 \u2014 20 years Year Capital April 1st, 1956.xS34,000.00 April 1st, 1957.x 21,000.00 > April 1st, 1958.x 22,000.00 April 1st, 1959.3,500.00 April 1st, 1960.3,500.00 April 1st, 1961.4,000.00 April 1st, 1962.4,000.00 April 1st, 1963.4,000.00 April 1st, 1904.4,500.00 April 1st, 1965.4,500.00 April 1st, 1966.5,000.00 April 1st, 1967 .5,000.00 April 1st, 1968 .5,000.00 April 1st, 1969.5,500.00 April 1st, 1970 .5,500.00 April 1st, 1971.6,000.00 April 1st, 1972:.6.000.00 April 1st, 1973.6,500.00 April 1st, 1974.6,500.00 April 1st, 1975.9,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $72,900.00 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments the first, 834,100.00, and the two others, 819,400.00 each, from 1956 to 1958 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St.Geneviève de Pierrefonds, County of Jacques-Cartier. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 2nd, 1955, Vol.87, No.13 1127 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, comté de Jacques-Cartier.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 20 avril 1955, à 8.heures p.m., en l'école Xo.1, Ue-Bizard, comté de Jacques-Cartier.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.L'Ile Bizard, (Comté de Jacques-Cartier), ce 30 mars 1955.Le Secrétaire-trésorier, ANDRÉ BOILEAU.530 Chemin Cherrier, Ile Bizard, .(Comté de Jacques-Cartier), P.Q.39579-0 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Aumand-Ouest (Comté de M issisquoi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Armand Lacoste, secrétaire-trésorier.11.N° 1.St-Annand-Ouest, comté de Missisquoi, jusqu'à >S heures p.m., lundi, le 18 avril 1955, pour l'achat «le 871.000.00 d'obligations «les commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Armand-Oucst, comté «le Missisquoi, datées du 1er avril 1955 et.remboursables par séries du 1er avril 1950 au 1er avril 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 11 ¦>% par année payable semi-an-nuellcment les 1er avril et 1er octobre «le chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en «late du S janvier 1955 \u2014 Construction de l'école du village.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1955.Ix! tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 871,000.00 \u2014 20 ans.Année\t\tCapital 1er avril\t1950.\t____x $15,500.00 1er avril\t\t 1er avril\t1958.\t.x 10,500.00 1er avril\t\t 1er avril\t1900.\t1.000.00 1er avril\t1901\t1.000.00 1er avril\t1902\t1,000.00 1er avril\t\t 1er avril\t1904 .\t1,000.00 1er avril\t\t 1er avril\t1966.\t1,500.00 1er avril\t1907.\t1,500.00 1er avril\t1908\t1,500.00 1er avril\t1909\t1,500.00 Capital ami interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or St.(îeneviève-de-Pierrefonds, County of Jacapies-Cartier.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity «late, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accnicd on the bonds to the date of their «lelivery is inchuled or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at meeting of the School Commissioners to be held on Weilnesday, April 20, 1955, at 8 o'clwk p.m., at School No.1, lie Bizard, County of Jacques-Cartier.The School Commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.He Bizard, (County of Jacques-Cartier), this March 30, 1955.ANDRÉ BOILEAU, Secretary-Treasurer.530 Cherrier Road.He Bizard, (County of Jacques-Cartier), P.Q.39579 Province of Quebec The school commissioners for the MUNICIPALITY of St.ArMAND-WeST (County of Missisquoi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Armand Lacoste, Secretary-Treasurer, R.No.1, St.Arinand-West, county of Missisquoi, until S o'clock Monday, April 18th, 1955, for the purchase of an issue of 871.000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of St.Armand-West, county of Missis«|iioi.dated April 1st, 1955 and redeemable serially from April 1st, 1950 to April 1st, 1975 inclusively, with interest, at a rate of not less than 3% or more than 4j-^% per annum, payable semi-annually on April 1st, ami October 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution «lated January 8th.1955 \u2014 Erection of village school.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from May 1st, 1955.The table of reileniption is as follows: Table of redemption \u2014 $71,000.00 \u2014 20 years.Year Capital April 1st, 1956.x 815,500.00 April 1st, 1957.x 16.000.00 April 1st, 1958.x 16,500.00 April 1st, 1959.1,000.00 April 1st, 1960.1,000.00 April 1st, 1961.1.000.00 April 1st.1962.1.000.00 April 1st, 1963.1.000.00 April 1st.1964.1,000.00 April 1st, 1905.1.000.00 April 1st, 1966.1.500.00 April 1st, 1967.1.500.00 April 1st, 1968.1,500.00 April 1st, 1909.1,500.00 1128 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 avril 1955, Tome 87, N° 18 1er avril 1970.1,500.00 1er avril 1971.1,500.00 1er avril 1972.1,500.00 1er avril 1973.1,500.00 1er avril 1971.2.000.00 1er avril 1975.2.000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 850,000.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements dont le premier de §16.668.00 et les deux autres de §16,-666.00 chacun, de 1956 à 1958 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet- emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital el intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bedford, comté de Missisquoi.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure, d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Bedford, comté de Missisquoi.' Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt, et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment «le leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «les commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 1S avril 1955, à 8 heures p.m., en l'école Pigeon Ilill.St-Armand-Oucst, comté de Missisquoi.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Armand-Ouest, (Comté «le Missisqu«)i), ce 28 mars 1955.Le Secivtairc-trésorier.ARMAND LACOSTE.R.N° 1.St-Armand-Ouest, (Comté de Missisquoi)', P.Q.39546-o Province de Québec Pahoisse de Saint-Féréol (Comté de Montmorency) Avis public est par les présentes donné que «les soumissions cachetées et endoss«'cs \"Soumissions pour obligations\" seront re«;ues par le soussigim, Albert Simard, secrétaire-trésorier, Saint-Féréol, comté «le Montmorency, jusqu'à S heures p.m'., lundi, le 18 avril 1955.pour l'achat, «le 810,000.00 d'obligations «le la paroisse «le Saint-Péirol, comté «le Montmorency, datées «lu 1er mai 1955 et remboursables par séries du 1er mai 1956 au 1er mai 1975 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4J4% par année payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre «le chaque année.Le taux d'intérêt peut être le môme pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement «l'emprunt No.4 \u2014 Consolhlation de tlette et financement sur obligations «les billets émis pour le règlement N° 2, contracté pour un système de protection contre l'incen
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.