Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 2 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1955-07-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 87, N° 26 2017 Vol.87, No.26 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch 3) Gazette officielle de Québec (publiés par lb gouvernement di la province) Quebec Official Gazette (published 8 y the provincial govern ment) PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 2 juillet 1955 Quebec, Saturday, July 2nd, 1955 RÉCEPTION DES ANNONCES RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Avis est par les présentes donné que l'ultime Notice is hereby given that the ultimate delay délai pour la réception de toute annonce, pour for receiving any advertising copy, for publication publication dans la Gazette officielle de Québec, in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, Wednesday of each week, during the months of durant les mois de juillet et août 1955.July and August, 1955.Québec, le 14 juin 1955.Quebec, June 14th.1955.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS, 40188-26-9-o RÉDEMPTI PARADIS.40188-26-9-o Queen's Printer.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.5316 20IS GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1965, Tome 87, N° 26 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publical ion, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de\" notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, REDEMPTI PARADIS.Hotel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933 \u2014 1-52 the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.38933\u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.10884-55) Bouthiliier Construction Limitée Avis est donné .qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1955, constituant en corporation: Bernard Lefebvre, de Montréal, Louis Preedman, de Hampstead, et Gabriel Houde, de Montréal-Sud, tous conseils en loi de la Reine, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Letters Patent (A.G.10884-55) Moui liillicr Construction Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent haye been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March, 1955, incorporating: Bernard Lefebvre, of Montreal, Louis Freedman, of Hampstead.and Gabriel Iloude, of Montreal-South, all Queen's Counsel of the judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2019 Exercer les operations «l'une compagnie de construction, sous le nom de \"Bouthillier Construction Limitée\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 300 actions ordinaires de S100 chacune et en 100 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en le village de Delson, dans le district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.O.11233-55) Brique St-Jean Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1955, constituant en corporation: Roméo Laquerre, industriel, Jean-Noël Laquerre, comptable, tous deux de Fortierville, et Henri Chassé, notaire, de Sainte-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de la brique, sous le nom de \"Brique St-Jean Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Deschail-lons, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.C.11554-55) Capeco Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentas en date du six juin 1955, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, de St-Larn-bert, Alexander Gordon Yeoman, commis en loi et Clifford (îeorge Meek, teneur de livres, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'huiles, graisses, produits chimiques, gaz, pétrole, gaz naturel et leurs produits et sous-produits, sous le nom de \"Capeco Limited\", avec un capital total dé $20,000, divisé en 200 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.- Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11284-55) Chez Capri Inc.Avie est donné qu'en vertu de la première parte de la.Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix mai 1955, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, avocat et conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross, avocat et Sarah Miller, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: To carry on the operations of a building company under the name of \"Bouthillier Construction Limitée\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 300 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be in the village of Delson in the judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11233-55) Brique St-Jean Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May 1955, incorporating: Roméo Laquerre, industrialist, Jean-Noël Laquerre, accountant, both of Fortierville, and Henri Chassé, notary, of Saint Foy, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in bricks, under the name of \"Brique St-Jean Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Deschaillons, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May 1955.C.E.CANTIN, 40189 Teputy Attorney General.(A.G.11554-55) Capeco Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1955, incorporating: Ernest William Mock-ridge, Manager, of St.Lambert, Alexander Gordon Yeoman, law clerk, and Clifford George Meek, bookkeeper, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in oils, greases, chemicals, gases, petroleum, natural gas and the products and by-products thereof, under the name of \"Capeco Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1955.C.E; CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11284-55) Chez Capri Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of May, 1955, incorporating: Samuel David Rudenko, advocate and Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross, advocate, and Sarah Miller, stenographer all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: 2020 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Manufacturer et exercer le commerce de lingerie, marchandises sèches, vêtements, textiles et tissus, sous le nom de \"Chez Capri Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.To manufacture and deal in lingerie, dry goods, clothing, textiles and fabrics, under the name of \"Chez Capri Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and into 300 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-0 Deputy Attorney General.(P.G.11020-55) Clou tier & Frere Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1955, constituant en corporation: Richard Crépeau, Guy C répeau, avocats, Lise Braun, sténographe, fille majeure, tous de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Faire affaires comme plombiers et ferblantiers, et, en général, exercer le commerce d'entrepreneurs en construction, sous le nom de \"Clou-tier & Frère Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 41, 1ère Ave., nord, Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.10832-55) Czechoslovak Welfare Association ., Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuvième jour de mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Karel Cvachovec administrateur, Jaroslav Fryml, industriel, Josef Hlavka, ingénieur, Eduard Jalin,\" voyageur, Zdenek Reznicek, architecte, tous de Montréal, Joseph Nemec, garagiste, Jaroslav Stribrny, industriel, tous deux de Ville St-Laurent, Jan Hruska, employé, d'Outremont, Bohuslav Jani-cek S.J., prêtre, de Montréal-ouest, et Rudolf Steinsky, chimiste, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir le bien-être moral, intellectuel, spirituel et physique du peuple tchécoslovaque en organisant dans la communauté un centre tchèque comprenant les services d'une bibliothèque, les sports, les divertissements et autres activités, sous le nom de \"Czechoslovak Welfare Association\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $100,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(A.G.11020-55) Clou tier & Frere Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May 1955, incorporating: Richard Crépeau, Guy Crépeau, advocates, Lise Braun, stenographer, fille majeure, all of Serbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To carry on the trades of plumbers and tinsmiths, and the business of building contractors generally, under the name of \"Cloutier & Frère Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 41, 1st, Avenue, North, Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.10832-55) Czechoslovak Welfare Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital : Karel Cvachovec, Executive, Jaroslav Fryml, Industrial, Josef Hlavka, Engineer, Eduard Jahn, Traveler, Zdenek Reznicek, Architect, all of Montreal, Josef Nemec, Garagist, Jaroslav Stribrny, Industrial, both of Ville St.Laurent, Jan Hruska, employee, of Outremont, Bohuslav Janicek S.J., Priest, of Montreal-West, and Rudolf Steinsky, Chimist, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote the welfare of Czechoslavak people morally, intellectually, spiritually and physically by organising within the community a szech center with library facilities, sports, amusements and other facilities, under the name of \"Czechoslovak Welfare Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2021 (P.O.! 1103-55) D & B Sound and Signals Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a_ été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de juin 1955, constituant en corporation: Marcel Lafontaine, Jean-Charles Biais, avocats, de Montréal, Rachel Bouchard, sténographe, de St-Basile-le-Grand, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'électriciens, travailleurs et manufacturiers d'accessoires électriques, électroniques et d'appareils de radio et radar, sous le nom de \"D & B Sound and Signais Inc.\", avec un capital de §40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 * C.E.CANTIN.(P.C.11211-55) Dion & Frère Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux mai 1955, constituant en corporation: Jacques Perron, avocat, Isabelle Beaubien, sténographe, tous deux de Québec, et Robert Perron, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Dion & Frère Limitée\", avec un capital total de $80,000, divisé en 800 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Raymond, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.10953-55) Electrical Appliances Merchants Association Association des Marchands d'Appareils Électriques Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: John Mishkin, Fred Weins-tein, Abe N.Gordon, Charles Bigras, marchands, de Montréal, Robert Dufault et Gaston Leroux, marchands, de Longueil, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Grouper les détaillants et marchands d'appareils électriques de la province de Québec en une organisation cohesive sans but lucratif, sous le nom de \"Electrical Appliances Merchants Association \u2014 Association des Marchands d'Appareils Électriques\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(A.G.11103-55) D & B Sound and Signais Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1955, incorporating: Marcel Lafontaine, Jean-Charles Biais, advocates, of Montreal, Rachel Bouchard, stenographer, of St-Basile-le-Grand, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of electricians and electrical, electronic, radio and radar workers and manufacturers, under the name of \"D & B Sound and Signals Inc.\", with a capital of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the sixth day of June, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11211-55) Dion & Frère Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May, 1955, incorporating: Jacques Perron, advocate, Isabelle Beaubien, stenographer, both of Quebec, and Robert Perron, advocate, of Si-lery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as general contractors under the name of \"Dion & Frère Limitée\", with a total capital stock of $80,000, divided into 800 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Raymond, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.10953-55) Electrical Appliances Merchants Association Association des Marchands d'Appareils Électriques Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital : John Mishkin, Fred Weinstein, Abe N.Gordon, Charles Bigras, merchants, of Montreal, Robert Dufault and Gaston Leroux, merchants, of Longueuil, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To unite into a non-profit cohesive organization retailers and dealers in electrical appliances in the Province of Quebec, under the name of \"Electrical Appliances Merchants Association\u2014 Association des Marchands d'Appareils Électriques\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Att-rney General. \\ (P.C.10778-55) Elk Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mai 1955, constituant en corporation: E.Léo Kolbcr, Léo Rosentzveig et Daniel Morris, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Elk Investment Corp.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur .général, le six mai 1955.L'Assistant-procureur général.40189 C.E.CANTIN.(A.G.10778-55) Elk Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1955, incorporating: E.Leo Kolbcr, Leo Rosentzveig and Daniel Morris, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Elk Investment Corp.\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General, (P.G.11215-55) Eugene Bolduc Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1955, constituant en corporation: Eugène Bolduc, entrepreneur plâtrier, Claude Picard, avocat, tous deux de Montréal, Roger Picard, comptable, de Ville Jacques-Cartier, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et de constructeurs, sous le nom de \"Eugène Bolduc Limitée\", avec un capital total de $40.000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4677, rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept irai 1955.L'Assistant-procureur général, 10189-o C.E.CANTIN.(P.G.11269-55) Fidelity Real Estate Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix mai 1955, constituant en corporation: Joseph Shapiro, C.R., avocat, de Westmount, Jonathan Joseph Robinson, avocat, et Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Fidelity Real Estate Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(A.G.11215-55) Eugene Bolduc Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day'of May, 1955, incorporating: Eugène Bolduc, plaster contractor, Claude Picard, advocate, both of Montreal, «Roger Picard, accountant, of the Town of Jacques-Cartier, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Eugène Bolduc Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preference shares of $100 each.The head office of the Company will be at.4677 St-Hubcrt St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11269-55) Fidelity Real Estate Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of May, 1955, incorporating: Joseph Shapiro, Q.C., advocate, of Westmount, Jonathan Joseph Robinson, advocate, and Ethel Yussem, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Fidelity Real Estate Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May, 1955./ C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.2022 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July Snâ, 196b\\ Vol.87, No.26 2023 (P.G.11248-55) Fourrures Mauriée Tessier Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1955, constituant en corporation: Louis-Philippe Larivière, avocat.Jeannette Du-mont, secrétaire, épouse contractuellcmcnt séparée de biens de Roger Beaulieu, et Marie Leclair, secrétaire, fdlc majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de la fourrure, sous le nomade \"Fourrures Maurice Tessier Limitée\", avec un capital total de 825,000, divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5450, lOième avenue, Rosemont, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-e C.E.CANTIN.(P.G.11142-55) Gandall Printing Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de mai 1955, constituant en corporation: Charles Wolfson, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Dorothy Smythe-Stcphens, Alva Phyllis Boyd, sténographes, toutes deux filles majeures, de Montréal et Aaron Hyman Mcttarlin, notaire, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs généraux, éditeurs, lithographes, graveurs, relieurs, compositeurs, sous le nom de \"Gandall Printing Co.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 100 actions ordinaires de S100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de mai 1955.\u2022 L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11126-55) Homcx Club Plan Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois mai 1955, constituant en corporation: Adrien R.Paquette, avocat, Françoise Frégeau, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, et Denise Racicot, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, de.Saint-Eustachc-sur-le-Lac, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandise sèche, quincaillerie, vaisselle, poterie, mobilier, jouets, articles de sport, sous le nom de \"Homex Club Plan Ltd.\", avec un capital total de 360,000, divisé en 400 actions communes de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.11248-55) Fourruri's Maurice Tessier Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1955, incorporating: Louis-Philippe Larivière, advocate.Jeannette Dumont, secretary, wife separate contractually as to property of Roger Bcaulicu, and Marie Leclair, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in furs, under the name of \"Fourrures Maurice Tessier Limitée\" with a total capital stock of $25,000, divided into 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 5456, 10th Avenue, Rosemount, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 401.S9 Deputy Attorney General.(A.G.11142-55) Gandull Printing Co.Notice is hereby given that tinder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1955, incorporating: Charles Wolfson, advocate, Q.C., Dorothy Smythe-Stephens, Alva Phyllis Boyd, stenographers, both spinsters of the full age of majority, of Montreal, and Aaron Hyman Mcttarlin, notary, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on trade or business of general printers, publishers, lithographers, engravers, book binders, book setters, under the name of \"Gandall Printing Co.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1955.C.E.CANTIN.40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11126-55) Il mu \\ Club Plan Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of May 1955, incorporating: Adrien R.Paqucttc, advocate, Françoise Frégeau, secretary, fille majeure, making use of her rights, both of the city and judicial district of Montreal, and Denise Racicot, secretary, fille majeure, making use of her rights, of Saint Eustache-sur-le-lac, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, hardware, crockery pottery, toys, furniture, sporting goods, under the name of \"Homex Club Plan Ltd.\", with a total capital stock of S60.000, divided into 400 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 2024 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.11132-55) j.II.Poirier Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1955, constituant en corporation: Gérard Beaupré, Marcel Trudeau, avocats, Suzanne Laframboise, secrétaire, célibataire majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur général en construction, sous le nom de \"J.H.Poirier Construction Ltée\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11132-55) j.II.Poirier Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1955, incorporating: Gérard Beaupré, Marcel Trudeau, advocates, Suzanne Laframboise, secretary, unmarried and having reached her majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general building contractor, under the name of \"J.H.Poirier Construction Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May 1955.C.E.CANTIN, 40189 \" Deputy Attorney General.(P.G.11299-55) j.O.Lebel Ltd.Avis est donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de mai 1955, constituant en corporation: Joseph Onésime Lcbel, instructeur, Isidore Reuben Prazoff, avocat, et Sarah Peters, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits et articles alimentaires, marchandises et effets s'y rapportant, sous le nom de \"J.O.Lebel Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera «à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11615-55) ' Lada Company, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de juin 1955, constituant en corporation: Ernest William Mockridge gérant, de St-Lambert, Guy Ambrose Miller, teneur de livres, de Verdun, et Cecil Bruce Cooke, secrétaire, He Claude, en la cité de Brucy, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces et activités d'une compagnie générale de terrains, immeubles, constructions et développement, sous le nom de \"Lada Company, Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.11299-55) j.o.Lebel Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1955, incorporating: Joseph Onésime Lebel, instructor, Isidore Reuben Prazoff, advocate, and Sarah Peters, stenographer and fille majeure, all of the city and judicial district of Montreal, for thé following purposes: To deal in food products and wares, merchandise and goods in connection thereof, under the name of \"J.O.Lebel Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.T)ated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11615-55) Lada Company, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1955, incorporating r Ernest William Mockridge, manager, of St.Lambert, Guy Ambrose Miller, bookkeeper, of Verdun, and Cecil Bruce Cooke, secretary, of He Claude, in the city of Brucy, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on the businesses and activities of a general land, real estate construction and development company, under the name of \"Lada Company, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2025 Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11146-55) Lake Sand & Gravel Ltd.Avis \"est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été,accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois mai 1955, constituant en corporation: J.-Éloi Lalonde, industriel, de Ville Mont-Royal, Paul Trépanier, avocat, de Lachine, et François Auclair, avocat, de ¦ Saint-Vincent-de-Paul, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : .Exercer le commerce de sable, gravier, de pierre, de granit, de brique et de ciment; faire affaires comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Lake Sand & Gravel Ltd.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.11390-55) La Société Historique Vaudreuil Soulanges Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Élic, écrivain, Jacques Dupire, rédacteur, Jacqueline Séguin, Rose Di Narzo, Madeleine Brabant, secrétaires, filles majeures, Jean-Charles Chapais, gérant, et Maurice Goudrault, avocat et conseiller en loi de Sa Majesté, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir un ou des musées, sous le nom de \"La Société Historique Vaudreuil Soulanges\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de -$50,000.Le siège social de la corporation sera à l'Ile Perrot Nord, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.11357-55).L'Assistance Maternelle de Laprairie Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Irène Dansereau, épouse de Julien Brisson, Eveline Longtin, épouse de Gérard Péladeau, Laurette Lacroix, épouse de Eugène Lussier, et Cécile Légaré, épouse de Arthur Leclerc, toutes ménagères, contractuellement séparées de biens de leurs maris et dûment autorisées par eux aux fins des présentes, de Laprairie, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11146-55) Lake Sand & Gravel Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor'of the Province of Quebec, bearing date the third day of May 1955.incorporating: J.-Éloi Lalonde, industrialist, of the Town of Mount Royal, Paul Trépanier, advocate, of Lachine, and François Auclair, advocate, of Saint-Vincent-de-Paul, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in sand, gravel, stone, granite, bricks and cement; carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Lake Sand & Gravel Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,500 common shares of a par value of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of May 1955.' C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11390-55) La Société Historique Vaudreuil Soulanges Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Robert Élie, writer, Jacques Dupire, editor, Jacqueline Séguin, Rose Di Narzo, Madeleine Brabant, secretaries, spinsters, Jean-Charles Chapais, manager, and Maurice Goudrault, advocate and Queen's Counsel, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To establish one or more museums, under the name of \"La Société Historique Vaudreuil Soulanges\".The amount to which the value of the immoveable property which to corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at.Isle Perrot, North, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11357-55) L'Assistance Maternelle de Laprairie Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Irène Dansereau, wife of Julien Brisson, Eveline Longtin, wife of Gérard Péladeau, Laurette Lacroix, wife of Eugène Lussier, and Cécile Légaré, wife of Arthur Leclerc, all housewifes, contractually separate as to property from their husbands and duly authorized by them for the purposes herein, of Laprairie, judicial district of Montreal, for the following purposes: 2026 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Venir en aide à la future mère, demeurant dans la Ville de Laprairie, sous le nom de \"L'Assistance Maternelle de Laprairie\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Laprairie, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau,du Procureur général, le dix-sept mai 1955.L'Assistant-procureur général, lOlSO-o C.E.CANTIN.(P.G.11129-55) Le Comité du Timbre de Noël de la Ville de la Tuque Inc.Avis est donné qu'en vertu de la., troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Roch Tremblay, médecin, Ré'jeanne Guerettc, garde-malade.Warren Murphy, commis, Antonio Bilodeau, Frank Spain, fils, Léon Lambert, commerçants, Léo Génois, comptable, tous de La Tuque, district judiciaire de Québec, et Alexandre Beaudet, médecin, de Gran'Mère, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Promouvoir et intensifier la lutte contre la tuberculose, sous le nom de \"Le Comité du Timbre de Noël de la Ville de La Tuque Inc.\".I\u201ec montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à La Tuque, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1955.L'Assistant-procureur général.40189-o C E.CANTIN., To assist expectant mothers residing in the Town of Laprairie, under the name of \"L'Assistance Maternelle de Laprairie\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Laprairie, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May 1955.C.E.CANTIN.40189 Deputy Attorney General.(A.G.11129-55) Le Comité du Timbre de Noël de la Ville de la Tuque Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of-Quebec, bearing date the fifth day of May, 1955.to incorporate as a corporation without share capital: Jean-Roch Tremblay, physician, Réjeanne Guerette, nurse.Warren Murphy, clerk, Antonio Bilodeau, Frank Spain, son, Léon Lambert, dealers, Léo Génois, accountant, all of La Tuque, judicial district of Quebec, and Alexandre Beaudet, physician of Gran'Mère.judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To promote and intensify the battle against tuberculosis, under the name of \"Le Comité du Timbre de Noël de la Ville de La Tuque Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $40,000.The.head office of the corporation will be at La Tuque, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of May, 1955.C.E.CANTIN.40189 Deputy Attorney General.(P.G.11221-55) (A.G.11221-55) Les Entreprises Publicitaires Inc.Les Entreprises Publicitaires Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the ninth day du neuf mai 1955, constituant en corporation: of May, 1955, incorporating: Jean-Paul Champa-Jean-Paul Champagne, agent de publicité, Louis- gne, publicity agent, Louis-Philippe Dussault, Philippe Dussault, comptable, tous deux de Sher- accountant, both of Sherbrooke, and Armand brooke, et Armand Champagne, comptable, d'As- Champagne, accountant, of Asbestos, all of the bestos, toils du district judiciaire de Saint-Fran- judicial district of Saint-Francis, for the following çois, pour les objets suivants: purposes: Exercer les opérations d'une compagnie de To operate as a publicity company under the publicité, sous le nom de \"Les Entreprises Publi- name of \"Les Entreprises Publicitaires Inc.\", citaires Inc.\", avec un capital total de $40,000, with a total capital stock of $40,000, divided into divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.400 common shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Sher- The head office of the Company will be at brooke, district judiciaire de Saint-François.Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Daté du bureau du Procureur général, le neuf Dated at the office of the Attorney General, mai 1955.this ninth day of May, 1955.L'Assistant-procureur général.C.E.CANTIN, 40189-o C.E.CANTIN.40189 Deputy Attorney General.(P.G.11338-55), Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Cœur de Montmagny Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: André Bernatchez, cultivateur et (A.G.11338-55) Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Cœur de Montmagny Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital : André Bernatchez, farmer QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.2G 2027 commerçant, Charles-Omer Dernier, shérif, Jean-Paul Tremblay, linotypiste, Cléophas Guay, employé civil, Patrice Corriveau, marchand-épicier, Réal Montminy, gérant, Louis-Philippe Morin, industriel, Maurice Labcrge, journalier, Raymond Doulet, comptable, et Marcellin Ga-mache, vendeur, tous de Montmagny, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants : Grouper en association les anciens élèves et amis du Collège Sacré-Cœur de Montmagny, sous le nom de \"Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Cœur de Montmagny Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $30,000.Le siège social de la corporation sera à Montmagny, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.10874-55) Ligue des Citoyens de Naudvillc Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six avril 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Léo Guy, chef de gare, Lauréat Lessard, papetier, Léo Frève, payeur, J.-Alcidc Simard, agent «l'assurance-vie, Frs-X.Simard, médecin, Stanislas Munger, charpentier, Gabriel Fortin, gérant caisse populaire, et Armand Pilote, cheminot, tous de Naudvillc, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Établir et maintenir dans la Ville de NawTville une association \"groupant des citoyens désireux d'étudier les questions sociales et-les règlements municipaux et scolaires de la Ville, sous le nom de \"Ligue des Citoyens de Naudvillc\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8500.Le siège social de la corporation sera à Naudvillc, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six avril 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.11465-55) Louis Pineau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mai 1955, constituant en corporation: Jean-Paul .Tobin, Louis-André Trudel, comptables, et Henri Chassé, notaire, tous de Sainte-Foy, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du bois, sous le nom de \"Louis Pineau Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 500 actions communes de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-François-Xavier-des-Hauteurs, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.and dealer, Charles-Omer Dernier, sheriff.Jean-Paul Tremblay, linotypist, Cléophas Guay, civil employee, Patrice Corriveau, merchant-grocer, Réal Montminy, manager, Louis-Philippe Morin.industrialist, Maurice Labcrge, laborer, Raymond Doulet, accountant, and Marcellin Gamaehe, salesman, all of Montmagny, judicial district of Montmagny, for the following purposes: To group into an association ex-pupils and friends of the Sacre-Heart College of Montmagny, under the name of \"Le Service d'Éducation du Collège' Sacré-Cœur de Montmagny Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav hold is to be limited, is $30,000.The head office of the corporation will be at Montmagny, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.10874-55) Ligue des Citoyens de Naudville Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of April 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Léo Guy, station master, Lauréat Lessard, paper maker, Léo Frève, paymaster, J.Alcide Simard, insurance agent, Frs.X.Simard, physician, Stanislas Munger, carpenter, Gabriel Fortin, manager of a People's Dank, and Armand Pilote, railwayman, all of Naudville, judicial district of Roberval, for the following purposes: To establish and maintain in the Town of Naudville, an association grouping together the citizens who arc desirous of making a study of social questions and the Town's municipal and school by-laws, under the name of \"Ligue des Citoyens de Naudville\".The amount to which the annual revenue of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $500.The head office of the corporation will be at Naudville, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of April 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11465-55) Louis Pineau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of May 1955, incorporating: Jean-Paul .Tobin, Louis-André Trudel, accountants, and Henri Chassé, notary, all of Saint Foy, judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of and deal in lumber, under the name of \"Louis Pineau Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 500 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint François-Xavier-des-Hauteurs, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of May 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.t 2028 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 (P.G.11070-55) Machineries Générales Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de \"Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1955, constituant en corporation: Louis Marceau, André Marceau et Jacques Marquis, tous avocats, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivanst: Manufacturer et exercer le commerce d'équipement industriel, commercial et agricole, de machinerie et outillage général, de pièces et accessoires de véhicules automobiles, sous le nom de \"Machineries Générales Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordiiaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept avril 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.(P.G.11149-55) Nat A m n off Oil & Coal Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux mai 1955, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, Harriet Beutel, teneur de livres, tous deux de Westmount, Joseph Roy Hoffman, avocat et Oscar Respitz, étudiant, de Montréal, tous du district judiicaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de combustible et d'appareils de chauffage, sous le nom de \"Nat Aronoff Oil & Coal Co.Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1955.» L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11100-55) N.Levi ne & Son Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour de mai 1955, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Exercer des affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"N.Levine & Son Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4855 avenue Isabella, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(A.G.11070-55) Machineries Générales Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Compagnies'.Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April 1955, incorporating: Louis Marceau, André Marceau and Jacques Marquis, all advocates, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in industrial, commercial and agricultural equipment, machinery and tools in general, parts and accessories for motor vehicles, under the name of \"Machineries Générales Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of a par value of $100 each and 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at Quebec, judicial district of Quebec.' Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of- April 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11149-55) Nat Aronoff Oil & Coal Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by, the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May, 1955, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, Harriet Beutel, bookkeeper, both of Westmount, Joseph Roy Hoffman, advocate, and Oscar Respitz, Student, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following puiposes: To deal in fuels and heating equipment, under the name of \"Nat Aronoff Oil & Coal Co.Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11100-55) N.Levine & Son Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of May, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch and Abraham Shuster, all advocates, of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, under the name of \"N.Levine & Son Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 4855 Isabella Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1966, Vol.87, No.26 2029 (P.G.11247-55) Plateau Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1955, constituant en corporation: Louis-Philippe Larivière, avocat, Jeannette Du-mont.secrétaire, épouse contractuellement séparée de biens de Roger Beaulieu, Harold LeBrock, comptable, Marie Leclair, secrétaire, célibataire majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Plateau Construction Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et en 150' actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera chambre 701, Édifice Carré Dominion, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-0 C.E.CANTIN.(P.G.11202-55) Sam Tabak Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuvième jour de mai 1955, constituant en corporation : Sam Tabak, marchand, Freda Copo-loff, Tabak épouse séparée de biens dudit Sam Tabak, Ida Copoloff, veuve de feu Sam Copoloff, de son vivant, marchand, tous de Lachine, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou chacun des commerces de drapiers, tailleurs, marchands de nouveautés, bonnetiers, modistes, costumiers, chapeliers, gantiers et fourreurs, sous le nom de \"Sam Tabak Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de mai 1955.\u2022 L'Assistant-procureur général, 40189 C.É.CANTIN.(P.G.10911-55) Service de Réhabilitation et de Recherches pour Alcooliques Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier juin 1955, constituant en corporation sans capital-actions: M.l'abbé Alphonse Giroux, directeur administratif du Conseil Central des Oeuvres, R.P.Gonzalve Poulin, directeur des Études des Facultés des Sciences Sociales, Roland Lelièvre, président Général Canadien des Cercles Lacordaire, Docteur Dominique Bédard, psychiatre, tous de Québec, et Albert Ménard, Conseiller en Orientation Professionnelle, de Charlesbourg, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Travailler à la réhabilitation des alcooliques, sous le nom de \"Service de Réhabilitation et de Recherches pour Alcooliques\".(A.G.11247-55)- Plateau Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1955, incorporating: Louis-Philippe Larivière, advocate, Jeannette Dumont, secretary, wife contractually separate as to property of Roger Beaulieu, Harold LeBrock, accountant, Marie Leclair, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Plateau Construction Inc.\", with a total capital stock of $20,-000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and into 150 preference shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at room 701, Dominion Square Building, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11202-55) Sam Tabak Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1955, incorporating: Sam Tabak, merchant, Freda Copoloff Tabak, wife separate as to property of the said Sam Tabak, Ida Copoloff, widow of the late Sam Copoloff, in his lifetime merchant, all of Lachine, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on all or any of the business of clothiers, tailors, drapers, hosiers, milliners, costumiers, .hatters, glovers, and furriers, under the name of \"Sam Tabak Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-0 Deputy Attorney General.(A.G.10911-55) Service de Réhabilitation et de Recherches pour Alcooliques Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of June 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Father Alphonse Giroux, managing director of the Central Council of Social Agencies, R.F.Gonzalve Poulin, Curriculum Headmaster of the Social Science Faculties, Roland1' Lelièvre, President of the Lacordaire Associations of Canada, Doctor Dominique Bédard, psychiater, all of Quebec, and Albert Ménard, adviser in Vocational Guidance, of Charlesbourg, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To further the rehabilitation of alcoholics.under the name of \"Service de Réhabilitation et de Recherches pour Alcooliques\". 2030 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut* posséder est de §300,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1955.L'Assistant-procureur général.40189-o C.E.CANTIN.(P.G.11220-55) Silvcnc Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour de mai 1955, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat et Conseil en Loi dé la Reine, de Westmount, Murray Lapin, avocat, de Hampstead et Morris Weiner, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles domestiques, nettoyeurs, désinfectants; et exercer un commerce général, sous le nom de \"Silvene Industries Ltd.\", avec un capital total de §20.000.divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §10 chacune et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 630 ouest, rue St-Paul Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11230-55) Solon Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de mai 1955, constituant en corporation: Mortimer Dolman, notaire, Kay Katz, secrétaire, épouse contractuellement séparée de biens de William Katz, de Montréal, et Jessie McWatters, secrétaire, épouse séparée de biens de Vernon William McWatters, en vertu des lois d'Ontario, de Verdun, tous du district judiciaire tie Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Solon Holdings Inc.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 100 actions ordinaires de §100 chacune et 300 actions privilégiées-de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.11574-55) Standard Investments Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du sixième jour de juin 1955, constituant en corporation : Zoë Pinsonnault Moissan, ménagère, épouse séparée de biens de Georges Etienne Moissan.et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Georges Etienne Moissan, comptable, tous deux de Ste-Foy, district judiciaire de Qué- The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is §300,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this first day of June 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11226-55) Silvene Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1955, incorporating: Marcus Meyer Sperber, advocate and Queen's Counsel, of West-mount, Murray Lapin, advocate, of Hampstead, and Morris Weiner, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in household articles, cleansers, disinfectants; to carry on a general mercantile business under the name of \"Silvene Industries Ltd.\", with a total capital stock of §20,000, divided into 1.000 common shares of the par value of $10 each and into 1,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at 636 St.Paul Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11230-55) Solon Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, ^bearing date the sixth day of May, 1955, incorporating: Mortimer Dolman, notary, Kay Katz.secretary, wife separate as to property of William Katz.by marriage con-tractf of Montreal, and Jessie McWatters, secretary, wife separate as to property of Vernon William McWatters, under the laws of Ontario, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Solon Holdings Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11574-55) Standard Investments Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1955, incorporating: Zoë Pinsonnault Moissan, house-keeper, wife separate as to property of Georges Etienne Moissan and duly authorized by him for the purpose of these presents, George Etienne Moissan, accountant, both of St.Foy, judicial districtof Quebec, and Louis QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2031 bec, et Louis Hector Moissan, comptable, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Standard Investments Incorporated\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1006.3e avenue, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce sixième jour de juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 CE.CANTIN.(P.G.11220-55) Summit Inc.Avis est d(Jnné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six mai 1955, constituant en corporation : Isidore M.Bobrove, Jack B.Bobrove, tous deux avocats, de Montréal et Ruth D.Budyk, secrétaire, fille majeure, d'Outremont, tous du district judiciaire (le Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et gérer un certain emplacement immobilier, sous le nom de \"Summit Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.13162-54) Victorian Order of Nurses Greater Montreal Branch Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux avril 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Eric Motzfeldt, courtiers d'assurances, de Montréal, Donald Newton Byers, conseil en loi de la Reine et A very Charles Dunning, comptable agréé, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Maintenir et développer des services d'infirmières visiteuses et domestiques dans la cité de Montréal et environs, sous' le nom de \"Victorian Order of Nurses Greater Montreal Branch\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $250,000.Le siège social de la corporation sera à 1246 rue Bishop, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 C.E.CANTIN.(P.G.10359-55) Victoria Rug Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de février 1955, constituant en Hector Moissan, accountant, of Montreal, judicial district .of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Standard Investments Incorporated\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1066, 3rd Avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of June, 1955.\u2022C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.11220-55) Summit Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1955, incorporating: Isidore M.Bobrove, Jack B.Bobrove, both advocates, of Montreal, and Ruth D.Budyk, secretary, spinster of the full age of majority, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and manage a certain immoveable emplacement, under the name of \"Summit Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each .and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.(A.G.13162-54) Victorian Order of Nurses Greater Montreal Brunch Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Eric Motz-fehlt.Insurance Broker, of Montreal, Donald Newton Byers, Queen's Counsel, and Avery Charles Dunning, Chartered Accountant, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To maintain and develop visiting and home nursing services in the city of Montreal and in the vicinity thereof, under the name of \"Victorian Order of Nurses Greater Montreal Branch\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited, is $250,000.The head office of the corporation will be at 1246 Bishop Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of April, 1955.C.E.CANTIN.40189-o \u2022 Deputy Attorney General.(A.G.10359-55) Victoria Rug Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of February, 1955, incorporating: Marcus Meyer 2032 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 corporation: Maurice Meyer Sperbcr, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Alan Bernard Gold, avocat, de Montréal et Murray Lapin, avocat, de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises fabriquées en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et sous-produits d'iceux; animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et revues périodiques, travaux artistiques, produits -chimiques et de beauté, produits du sol, de la mer et dse forêts,.sous le nom de \"Victoria Rug Company Ltd.\", avec un capital total de $20,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4442 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de février 1955.L'Assistant-procureur général, 40189 CE.CANTIN.Action en séparation de biens Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 375,095.Dame Pearl Edith McBain, épouse commune en biens avec Ross Frederick Rowell, tous deux de la Cité et district de Montréal, demanderesse vs ledit Ross Frederick Rowell, machiniste, défendeur: Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le lOème jour de juin 1955.Montréal, le 17ème jour de juin 1955.Le D.P.S.C, RAOUL CREVIER.Le Procureur de la demanderesse, 40204-o ROYAL E.C.WERRY, C.R.Action en séparation de corps et de biens Canada, province de Québec, district de Gaspé, Cours Supérieure, Percé, N° 4146.Elsie Blanche Patterson, maîtresse de maison, épouse séparée de biens de Clarence Melvin Zuck, mineur, du village de Gaspé, comté et District de Gaspé, demanderesse, vs Clarence Melvin Zuck, mineur du village de Gaspé, comté et district de Gaspé, défendeur.Une action en séparation de corps a été instituée dans cette cause le 13 juin 1955, à Percé.Gaspé le 21 juin 1955.Les Procureurs de la Demanderesse, 40192-o PIDGEON & DUSSAULT.Avis divers Avis est donné que \"Lakeside Heights Baptist Church,\" 93 avenue St-Louis, Lakeside Heights, Québec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour obtenir sa constitution en corporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines Sperber, advocate and Queen's Counsel, of West-bount, Alan Bernard Gold, advocate, of Montreal, and Murray Lapin, advocate, of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise made, in whole or in part of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art, chemical and beauty- products, land, sea and forest products, under the name of \"Victoria Rug Company Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of the par value of $100 each and into 100 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at 4442 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of February, 1955.C E.CANTIN, 40189-o Deputy Attorney General.Action for Separation as to Property Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.375,095.Dame Pearl Edith McBain, wife common as to property with Ross Frederick Rowell, both of the City and district of Montreal, plaintiff, vs the said Ross Frederick Rowell, machinist, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case on the tenth day of June, 1955.Montreal, seventeenth day of June, 1955.RAOUL CREVIER, D.P.S.C.ROYAL E.C WERRY, Q.C, 40204 Attorney for the Plaintiff.Action for Separation as to Bed and Board and Property Canada, province of Quebec, district of Gaspé, Superior Court, Percé, No.4146.Elsie Blanche Patterson, housewife, wife separate as to property of Clarence Melvin Zuck, of the village of Gaspé, county & district of Gaspé, province of Quebec, plaintiff vs Clarence Mclviri Zuck, miner of the said village of Gaspé, county & district of Gaspé, Province of Quebec, defendant.An action for separation as to bed has been instituted in this case on the 13th day of June 1955, at Percé.Gaspé, June 21st, 1955.PIDGEON & DUSSAULT, 40192-o Attorneys for Plaintiff.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that the \"Lakeside Heights Baptist Church,\" 93 St.Louis Avenue, Lakeside Heights, Quebec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, Chapter 311 of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2033 Églises, chapitre 311 des statuts refondus de la province de Québec 1941 et amendements.Montréal, P.Q., 9 juin 1955.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.132 ouest, rue St-Jacqucs, Montréal, P.Q.40110-24-4 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu un des triplicata de la déclaration de fondation de la \"Coopérative d'Électricité du Canton d'Iberville\" en date du quinze juin 1955, dont le siège social est situé à Sault-au-Mouton, dans le comté de Saguenay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi de 1'electrification rurale (9 George VI, chapitre 48).Donné au bureau du Secrétaire de la Province le vingt-deux juin 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 40189-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Chantier Coopératif de l'U.C.C.de Grande Baie\", en date du 25 mars 1955, dont le siège social est situé à Grande-Baie, dans le comté de Chicoutimi, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le dix mai 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 40193-o JEAN BRUCHÉSI.Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941 and Amendments.Montreal, P.Q.June 9th, 1955.CERINI & JAMIESON, Solicitors for the petitioner.132 St.James St.West, Montreal, P.Q.40110-24-4-o Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the declaratoin of foundation of the \"Coopérative d'Électricité du Canton d'Iberville\", under date of June fifteenth 1955, whereof the head office is at Sault-au-Mouton, in the County of Saguenay, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 22 of the Rural Electrification Act (9 George VI, chapter 48).Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-second day of June 1955.JEAN BRUCHÉSI, 40189 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Chan-tier Coopératif de l'U.C.C.de Grande Baie\" under date of March 25, 1955, whereof the head office is at Grande Baie, in the County of Chicoutimi, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this tenth day of May 1955.JEAN BRUCHÉSI, 40193 Under Secretary of the Province.Avis est parles présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative d'Aqueduc de l'Anse au Griffon\", en date du 5 juin 1955, dont le siège social est situé à l'Anse-au-Griffon, dans le comté de Gaspé-Sud, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ' le dix juin 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 40194-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.l 1338-55) Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Coeur de Montmagny Inc.Extrait des règlements généraux de la corporation ci-haut mentionnée concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs de dix à treize: \"8.Conseil de direction \u2014 A) Le conseil de direction se composera d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire, de six conseillers (directeurs), du directeur du Collège Sacré-Cœur de Montmagny et des deux titulaires des classes de finissants de ce Collège.\" Certifié vraie copie, Montmagny, le 31 mai 1955.Le Secrétaire, 40195-o RAYMOND BOULET.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Coopérative d'Aqueduc de l'Anse au Griffon\" under date June 5, 1955, whereof the head office is at L'Anse-au-Griffon, in the county of Gaspé-South and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this tenth day of June, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 40194 Under Secretary of the Province.(A.G.11338-55) Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Coeur de Montmagny Inc.Excerpt of the general by-laws of the above-mentioned corporation concerning the increase in the number of its Directors from ten to thirteen: \"8.Board of Directors \u2014 A) The Board of Directors shall be composed of a President, a Vice-President, a Treasurer, a Secretary, of Six Advisors, (directors) of the Director of the Sacrcd-Heart College of Montmagny and of the two professors of the graduating classes of this College.\" Certified true copy, Montmagny, May 13, 1955.RAYMOND BOULET, 40195 Secretary. 2034 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N°'2C> (P.G.10902-54) Montreal Fluorescent Service Company Règlement N° 5 \"1° Que le nombre des directeurs de lu compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois (3) à quatre (4) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de quatre (4) directeurs.2° Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et révisés pour donner effet à ce règlement.\" Décrété ce 13e jour de mai 1955.Certifié vraie copie.Le Président, 40200 MERVIN WEISS.(P.G.11154-55) Comité de Moralité Publique du Diocèse de St-Jean* Extrait des règlements généraux de la corporation ci-haut mentionnée, tels qu'adoptés à l'assemblée générale tenue le 4 mai 1955, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de huit à vingt et un: \"3° Le nombre des membres du bureau de direction est, par les présentes, porté à 21, et 7 directeurs peuvent, à une assemblée régulièrement convoquée, constituer quorum.\" Copie conforme Le Secrétaire, 40201-o POTHIER FERLAND.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Camionneurs de la Région de Chicoutimi, Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt-neuf avril 1955.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Chicoutimi, dans le comté de Chicoutimi.Le Sous-secrétaire de la Province, 40202-o JEAN BRUCHÉSI.Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a autorisé le sept juin 1955, le changement de nom du \"Syndicat des Travailleurs dans la Chaussure de l'Assomption\", dont la constitution en syndicat professionnel a été autorisée le 31 janvier 1951, et dont le siège social est situé à l'Assomption, dans le comté de l'Assomption, en celui de \"Syndicat des Travailleurs en Chaussures de l'Assomption, Incorporée\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le dix-sept juin 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 10203-o JEAN BRUCHÉSI.(A.G.10902-54) Montreal Fluorescent Service Company By-Law No.5 \"1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three (3) to four (4) so that the board of directors of the Company shall hereafter be composed of four (4) directors.2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 13th day of May, 1955.Certified true copy.MERVIN WEISS, 40200-o President.(A.G.11154-55) Comité de Moralité Publique du Diocèse de St-Jean Excerpt from general by-laws of the above-mentioned corporation, as adopted at a general meeting held on May 4, 1955, concerning the increasing of the number of directors from eight to twenty-one: \"3.The number of members of the Board of Directors is hereby increased to 21, and 7 directors may, at a meeting duly called, constitute a quorum.\" True copy POTHIER FERLAND, 40201 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act)* The formation of an association under the name of \"L'Association des Camionneurs de la Région dé Chicoutimi, Inc.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interest of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on April twenty-ninth, 1955.The principal place of business of the said professional syndicate is at Chicoutimi, in the countv of Chicoutimi.JEAN BRUCHÉSI, 40202 Under Secretary of the Province.Notice of change of name (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized, on the seventh day of June 1955, the changing of the name of the \"Syndicat des Travailleurs dans la Chaussure de l'Assomption\", the incorporation of which as a Professional Syndicate had been authorized on January 3], 1951, whereof the head office is located at l'Assomption, in the County of l'Assomption, to that of \"Syndicat des Travailleurs en Chaussures de l'Assomption, Incorporée\", and such, pursuant to the provisions of section 7 of the Professional Svndicates' Act, R.S.Q.1941, chapter 162.(iiven at the office of the Provincial Secretary, the seventeenth dav of June 1955.JEAN BRUCHÉSI, 40203 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2035 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de St-Philippe de Montréal*', en date du 17 mai 1955, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le deux juin 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 40208-o JEAN BRUCHÉSI.Montreal Industrial Land Company, Limited Sommaire du règlement spécial \"A\" La distribution de l'actif de la compagnie entre ses actionnaires au pro rata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux est, par les présentes, autorisée.Certifié vrai sommaire du règlement spécial \"A\" de Montreal Industrial Land Company, Limited.Montréal, P.Q., 27 juin 1955.Le Secrétaire, 40214 ERIC B.FINLEY.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de St-Philippe de Montréal\", under date of May 17, 1955, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this second day of June 1955.JEAN BRUCHÉSI, 4020S Under Secretary of the Province.Montreal Industrial Land Company.Limited Summary of special By-law \"A\" The distribution of the assets of the Company ratably amongst its Shareholders to the number of shares held by each is hereby authorized.Certified true summary of special By-law \"A\" of Montreal Industrial Land Company, Limited.Montreal, P.Q., June 27th, 1955.ERIC B.FINLEY, 40214-o Secretary.Arrêté en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 665 Québec, le 15 juin 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 44 du 14 janvier 1954.amendé par les arrêtés en conseil numéros 601-E, et 773-C des 9 juin et 28 juillet 1954, 100-D et 101-B du 26 janvier 1955, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 29 janvier 1955; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; îi est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 44, soit modifié comme suit: 1° L'Association des Employés Coiffeurs pour Dames de Québec Inc.\" est acceptée comme partie co-contractante de deuxième part.Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 665 Quebec, June 15th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the men's and ladies' hairdressing trades in the district of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the collective agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the men's and ladies' hairdressing trades in the district of Quebec, rendered obligatory by the decree number 44 of January 14th, 1954, amended by Orders in Council numbers 601-E and 773-C of June 9th and July 28th, 1954, 100-D and 101-B of January 26th, 1955, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of Januarv 29th, 1955; Whereas the objections set forth have been duly considered, es required by the Act; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That the said decree, number 44, be amended as follows: 1.\"L'Association des Employés Coiffeurs pour Dames de Québec, Lie.\" is accepted as co-contracting party of the second part. 2036 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 2° Au paragraphe \"a\" de l'article 2, les alinéas suivants sont ajoutés: \"i.Coiffeur pour hommes, classe \"A\" désigne un coiffeur pour hommes qui a obtenu du Comité paritaire, suivant les prescriptions de ses règlements, un certificat le qualifiant comme tel.\" \"ii.Coiffeur pour hommes, classe \"B\" désigne un coiffeur pour hommes qui a obtenu du Comité paritaire, suivant les prescriptions de ses règlements, un certificat le qualifiant comme tel.\" 3° Le paragraphe \"/\" de l'article 2 est remplacé par les suivants: \"f-l° Coiffeur pour dames classe \"A\", désigne un coiffeur pour dames qui a obtenu du Comité paritaire, suivant les prescriptions de ses règlements, un certificat le qualifiant comme tel.\" \"1-2° Coiffeur pour dames classe \"B\", désigne un coiffeur pour dames qui a obtenu du Comité paritaire, suivant les prescriptions de ses règlements, un certificat le qualifiant comme tel.\" 4° L'article 3 est abrogé et remplacé par le suivant: \"3° Certificats de qualifications: a) Les.certificats de qualification émis par le Comité paritaire appartiennent à leurs détenteurs, lesquels doivent les garder constamment au lieu de leur travail.5° L'article 6 est abrogé et remplacé par le suivant : \"6° Salons dans les zones I et 11: a) Dans le territoire des zones I et II, aucun salon ne peut être tenu, s'il n'y travaille au moins un maître-coiffeur pour hommes dans un salon de coiffeur pour hommes, un maître-coiffeur pour dames dans un salon de coiffure ou une manucure-esthéticienne dans un salon de beauté.b) Les coiffeurs pour hommes des zones I et II détenant un certificat de qualification lors de la mise en vigueur du décret numéro 44 du 14 janvier 1954 ne sont pas soumis au paragraphe précédent.c) Dans le territoire des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aucun salon ne peut être tenu, s'il n'y travaille au moins un coiffeur pour hommes, classe B, dans un salon de coiffeur pour hommes, un coiffeur pour dames, classe B, dans un salon de coiffure ou une manucure-esthéticienne dans un salon de beauté.d) Les coiffeurs pour hommes, classe B, ne peuvent exercer leur métier ailleurs que dans le territoire des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X.\" 6° L'article 23 est modifié en y ajoutant la municipalité de St-Félix du Cap-Rouge.7° Au paragraphe \"a\" de l'article 24, les mots: \"cinquante (50) heures\", seront remplacés par les mots \"quarante-neuf heures (49)\", et les mots: \"Les samedi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 8.00 p.m.\"sont remplacés par les mots: \"Les samedi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.\" 8° Le paragraphe \"6\" de l'article 24 est abrogé et remplacé par le suivant: \"b) Cependant, dans la cité de Lévis, la durée hebdomadaire du travail est de cinquante et une (51) heures, réparties ainsi: Les lundi, mardi, jeudi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.;' Le mercredi: de 8.00 a.m.à midi, à l'exception des semaines comptant un jour de fête chômée mentionnée à l'article 11 et à l'exception du mercredi de la Semaine Sainte où dans les deux cas, a durée du travail est prolongée à 6.00 p.m.; 2.In subsection \"a\" of section 2, the following paragraphs are added: \"i.Mens' hairdresser, class \"A\", means a men's hairdresser who has obtained from the Parity Committee, in pursuance of the provisions of its by-laws, a certificate that qualifies him as such.\" \"ii.Men's hairdresser, class \"B\", means a men's hairdresser who has obtained from the Parity Committee, in pursuance of the provisions of its by-laws, a certificate that qualifies him as such.\" 3.Subsection \"/\" of section 2 is replaced by the following: \"f-1.Ladies hairdresser, class \"A\", means a ladies hairdresser who has obtained from the Parity Committee, in pursuance of the provisions of its by-laws, a certificate that qualifies him as such.\" \"f-2.Ladies hairdresser, class \"B\", means a ladies hairdresser who has obtained from the Parity Committee, in pursuance of the provisions of its by-laws, a certificate that qualifies him as such.\" 4.Section 3 is deleted and the following substituted therefor: \"3.Certificates of competency: a) Certificates of competency issued by the Parity Committee belong to their holders; the latter shall keep their certificates constantly where they ply their trade.5.Section 6 is deleted and the following subti-tuted therefor: \"6.Parlors in zones I and II: a) In the territory of zones I and II, no parlor may be operated without the services of at least one men's master hairdresser in the case of a men's hairdressing parlor, and at least one ladies master-hairdresser or one manicure-aesthetician in the case of a beauty parlor./;) Men's hairdressers of zones I and II holding a certificate of competency at the time of the coming into force of the decree No.44 of January 14th, 1954, are not subject to the provisions of the foregoing subsection.c) In the territory of zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X, no parlor may be operated without the services of at least one men's hairdresser, class B, in the case of a men's hairdressing parlor, and at least one ladies hairdresser, class B, in the case of a hairdressing parlor, or one manicure-aesthetician in the case of a beauty parlor.d) Men's hairdressers, class B, shall not ply their trade outside the territory of zones III, IV, V, VI, VII, VIII, 1% and X.\" 6.Section 23 is amended by adding the municipality of St.Félix du Cap-Rouge.7.In subsection \"a\" of section 24, the words: \"fifty (50) hours\" are replaced by the words \"forty-nine (49) hours\" and the words \"Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.\" are replaced by the words \"Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.\" 8.Subsection \"b\" of section 24 is deleted and the following substituted therefor: \"c) However, in the city of Levis, the weekly duration of wonk consists of fifty-one (51) hours, distributed as follows: Monday, Tuesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.; Wednesday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon), excepting weeks in which falls a holiday mentioned in section II and excepting Wednesday of the Holy Week where, in both cases, the duration of work is extended to cease at 6.00 p.m. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2037 lies vendredi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.\" 9° Le premier alinéa du paragraphe \"a\" de l'article 25, est remplacé par le suivant: \"a) Salaires minima: Le salaire minima d'un employé régulier est de 835.00 par semaine, plus une commission de 50% des recettes de son travail dépassant 845.00 par semaine.\" 10° A l'article 26, le prix minimum du prix de la coupe des cheveux pour adultes, dans la zone I, est augmenté de $0.65 à 80.70 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et de 80.70 à 80.75 les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.11° Le premier alinéa du paragraphe \"a\" «le l'article 29 est remplacé par le suivant: \"a) Salaires minima: Le salaire minimum'd'un employé régulier est de 835.00 par semaine, plus une commission de 50% des recettes de son travail dépassant 845.00 par semaine.\" 12° Les paragraphes \"b\" et \"c\" de l'article 29 sont amendés en y remplaçant les mots: \"est de $5.00 par jour\", par les mots: \"est de $6.00 par jour\".13° L'article 30 est abrogé et remplacé par le suivant: \"30° Prix minima des services: I.es employeurs, les artisans et les salariés doivent charger à la clientèle les prix minima suivants pour les services ci-après énumérés: Zone II Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.$0.60 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.65 Coupe de cheveux pour enfants au-dessous de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.35 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.45 Coupe de cheveux en brosse ou aux ciseaux .80 Coupe de la barbe.35 Massage.50 Shampooing.50 Flambage des cheveux.35 Lotion.*.35 Tonique.35 Aiguisage de rasoir.40\" 14° Le paragraphe \"a\" de l'article 32 est abrogé et remplacé par le suivant: \"32° Heures de travail: a) La durée hebdomadaire du travail est de cinquante et une (51) heures réparties comme suit: Le lundi: de 8.00 a.m.à midi; Les mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Les vendredi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; Le samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.\".15° Aux articles 34 et 73 le prix minimum de la coupe des cheveux pour adultes est augmenté-de 0.65 à 0.70 tous les jours.16° L'article 42 est amendé en substituant les prix minima suivants à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour les services ci-après énumérés: Zone V \"Coupe de cheveux pour adidtes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.$0.50 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.55 Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.9.The first paragraph of subsection \"a\" of section 25 is replaced by the following: \"a) Minimum wages: The minimum wages of a regular employee shall be $35.00 per week, plus a 50% commission of those receipts of his work exceeding $45.00 per week.\" 10.In section 26.the minimum price of adults' haircuts, in zone I, is increased from $0.65 to $0.70 on Monday.Tuesday, Wednesday, Thursday and from $0.70 to $0.75 on Friday, Saturday and holiday eves.11.The first paragraph of subsection \"a\" of section 29 is replaced by the following: \"a) Minimum wages: The minimum wages of a regular employee shall be $35.00 per week plus a 50% commission on those receipts of his work exceeding $45.00 per week.\" 12.Subsections \"6\" and \"c\" of section 29 are amended by replacing the words \"is $5.00 per day\" by the words \"is $6.00 per day\".13.Section 30 is deleted and the following substituted therefor: \"30.Minimum prices of services: The employers, artisans and employees shall charge to the customers the following minimum prices for the services hereafter enumerated: Zone II Haircut, for adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.$0.60 Friday, Saturday and holiday eves.0.65 Haircut children under 14 years of age.Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.35 Friday, Saturday and holiday eves.0.45 Haircut with scissors or brushcut.0.80 Shave.0.35 Massage.0.50 Shampoo.0.50 Singeing of the hair.0.35 Lotion.0.35 Tonic.0-.35 Razor setting.0.40\" 14.Subsection \"a\" of section 32 is deleted and the following substituted therefor: \"32.Hours of work: a) The weekly duration of work shall consist of fifty-one (51) hours, distributed as follows: Monday: 8.00 a.m.yo 12.00 (noon); Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.; Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.; Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.\" 15.In sections 34 and 73, the minimum price of a haircut for adults is increased from $0.65 to $0.70 every day of the work week.16.Section 42 is amended by substituting the following minimum prices for those now mentioned in the decree for the services hereunder enumerated : Zone V \"Haircut for adults: Mondav, Tuesdav, Wednesday and Thursday.$0.50 Friday, Saturday, and holiday eves.0.55 2038 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1965, Tome 87.A'° 26 Coupe de cheveux pour enfants au-dessous de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi et jeudi: a) avant cinq (5.00) heures p.m.30 b) après cinq (5.00) heures p.m.40 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.45 Coupe de la barbe.30\" 17° L'article 54 est amendé en substituant les prix minima suivants à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour les services ci-après énumérés: Zone VIII \"Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.$.60 Samedi et veilles de fêtes chômées.65 Coupe de cheveux pour enfants au-dessous de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.40 Samedi et veilles de fêtes chômées.45 Coupe de la barbe.35\" 18° L'article 55 est amende en ajoutant les municipalités de village d'East-Broughton et d'East-Broughton Station.19° L'article 56, paragraphe \"a\", est remplacé par le suivant: \"56° Heures de travail: a) La durée hebdomadaire du travail est de cinquante-sept (57^) heures et demie réparties comme suit: Les lundi, mardi et jeudi: de 8.00 a.m.à 7.30 p.m.; Le mercredi: de 8.00 a.m.à midi; Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.\".20° L'article 58 est amendé en ajoutant ou substituant les prix minima suivants à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour les services ci-après énumérés: Zone IX \"Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.$0.55 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées .65 Coupe de cheveux en brosse pour enfants au-dessous de 14 ans.50.Coupe de la barbe.35 Aiguisage de rasoir.40\" 21° A l'article 59 les mots \"que la durée de ce travail ne dépasse pas une heure\", sont remplacés par les mots \"qu'en aucun cas, ce travail ne dure plus d'une (1) heure après l'heure de clôture\".22° L'article 62 est amendé en y ajoutant la municipalité de St-Flélix de Cap-Rouge.23° Le sous-paragraphe \"h\" du paragraphe \"a\" de l'article 64 est amendé en ajoutant après les mots \"Pour le coiffeur\", le mot: \"classe A\".24° Le sous-paragraphe \"iii\" du paragraphe \"a\" de l'article 64 est amendé en remplaçant les mots: \"Pour l'assistant-coiffeur\" par les mots: \"Pour le coiffeur, classe B\".25° Le sous-paragraphe \"ii\" du paragraphe \"o\" de l'article 68 est amendé en ajoutant après les mots: \"Pour le coiffeur\", les mots: \"classe A\".26° Le sous-paragraphe \"iii\" du paragraphe \"o\" de l'article 68 est amendé en remplaçant les mots: \"Pour l'assistant-coiffeur\", par les mots: \"Pour le coiffeur, classe B\".27° Le paragraphe \"a\" de l'article 72 est modifié en biffant les mots: \"plus une commission de 10% des recettes de son travail dépassant $25.00 par semaine\".Haircut for children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday: a) before 5.00 p.m.0.30 b) after 5.00 p.m.0.40 Friday, Saturday and holiday eves.0.45 Shave.0.30'j 17.Section 54 is amended by substituting the following minimum prices for those now mentioned in the decree for the services hereunder enumerated : Zone VIII \"Haircut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.$0.60 Satuday and holiday eves.0.65 Haircut for children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.0.40 Saturday and Holiday eves.0.45 Shave.0.35\" 18.Section 55 is amended by adding the village municipalities of Easl-Broughton and East-Broughton Station.19.Section 56, subsection \"a\", is replaced by the following: \"56.Hours of work: a) The weekly duration of work shall consist of fifty-seven hours and one half (57J^), distributed as follows: Monday, Thuesday and Thursday: 8.00 a.m.to 7.30 p.m.; Wednesday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon); Friday.Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.\" 20.Section 58 is amended by adding or substituting the following minimum prices for those now mentioned in the decree for the services hereunder enumerated: Zone IX \"Haircut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.$0.55 Friday, Saturday and holiday eves.0.65 Brushcut for children under 14 years of age.0.50 Shave.0.35 Razor setting.0.40\" 21.Section 59 is amended by adding the following words thereto: \"after closing time.\" 22.Section 62 is amended by adding the municipality of St.Félix-de-Cap-Rouge.23.Paragraph \"ii\" of subsection \"o\" of section 64 is amended by adding, before the word \"Hairdressers\" the word \"Class A\".24.Paragraph \"iii\" .of subsection \"a\" of section 64 is amended by replacing the words \"Assistant hairdressers\" by the words \"Class B hairdressers\".25.Paragraph \"ii\" of subsection \"«\" of section 68 is amended by adding, before the word \"Hairdressers\" the work \"Class A\".26.Paragraph \"iii\" of subsection \"a\" of section 68 is amended by replacing the words \"Assistant hairdressers\" by the words \"Class B hairdressers\".27.Section 72, subsection \"a\" is amended by deleting the words \"plus a 10% commission on the receipts of their work exceeding $25.00 per week.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, J955, Vcl.87, No.26 2039 28° Les paragraphes \"//' et \"c\" de l'article 72 sont modifiés en biffant les mots: \"plus une commission de 10% sur les recettes de son travail dépassant le double de son salaire gagné\".29° Le paragraphe \"a\" de l'article 76 est modifié en biffant les mots: \"plus une commission de 10% des recettes de son travail dépassant 825.00 par semaine\".30° Les paragraphes \"//' et \"c\" de l'article 76 sont modifiés en biffant les mots: \"plus une commission de 10% sur les recettes de son travail dépassant le double'de son salaire gagné\".31° Le paragraphe \"a\" suivant est ajouté à l'article 79: \"a) Cependant, durant les mois de juin, juillet et août, la durée hebdomadaire du travail est de cinquante-neuf (59) heures réparties de la façon suivante: Les lundi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; Le mardi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Les vendredi et veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.; Le samedi: de 8.00 a.m.à 1.00 p.m.\" 32° Le paragraphe \"a\" de l'article 80 est modifié en biffant les mots: \"plus une commission de 10% des recettes de son travail dépassant 825.00 par semaine.33° Les paragraphes \"b\" et \"c\" de l'article 80 sont modifiés en biffant les mots: \"plus une commission de 10% sur les recettes de son travail dépassant le double de son salaire gagné\".34° L'article 81 est amendé en ajoutant ou substituant les prix minima suivants à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour les services ci-après mentionnés: \"Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.80.50 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.0.55 Coupe de cheveux pour enfants au-dessous de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi et jeudi a) avant 5.00 p.m.0.30 b) après 5.00 p.m.0.40 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.0.45 Indéfrisable \"à froid\", sans charge additionnelle pour la coupe de cheveux, le shampooing et l'ondulation à l'eau S.00 Ondulation à l'eau.0.75 Shampooing.0.50\" 35° Le paragraphe \"a\" de l'article 84 est modifié en biffant les mots: \"plus une commission de 10% des recettes de son travail dépassant 825.00 par semaine\".46° Les paragraphes \"6\" et \"c\" de l'article 84 sont modifiés en biffant les mots: \"plus une commission de 10% sur les recettes de son travail dépassant le double de son salaire gagné\".37° Le paragraphe \"o\" de l'article 88 est modifié en biffant les mots: \"plus une commission de 10% ees recettes de son travail dépassant 825.00 par semaine\".38° Les paragraphes \"//' et \"c\" de l'article 88 sont modifiés en biffant les mots: \"plus une commission de 10% sur les recettes de son travail dépassant le double de son salaire gagné\".39° L'article 8.9 est amendé en réduisant le prix de l'indéfrisable à froid\" à $7.00.40° L'article 93 est amendé en substituant les prix minima suivants à ceux qui apparaissent actuellement dans le décret pour les services ci-après énumérés: \"Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.$0.60 28.Section 72, subsections \"b\" and \"c\", is amended by deleting the words :\"plus a 10% commission on the receipts of his work exceeding double the wages earned\".29.Section 76, subsection \"a\", is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of their work exceeding 825.00 per week\".30.Section 76, subsection \"6\" and \"c\", is amended by deleting the words \"plus a 10% commission on the receipts of his work exceeding double the wages earned.\" 31.The following subsection \"a\" is added to section 79: \"a) However, during the months of June, July and August, the weekly duration of work shall consist of fifty-nine (59) hours, distributed as follows: Monday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.; Tuesday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.; Friday and holiday eves: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.; Saturday: 8.00 a.m.to 1.00 p.m.\" 32.Section 80, subsection \"a\", is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of their work exceeding 825.00 per week.\" 33.Section 80, subsections \"b\" and \"c\", is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of his work exceeding double the wages earned.\" 34.Section 81 is amended by adding or substituting the following minimum prices for those now mentioned in the decree for the services hereafter mentioned: Haircut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.$0.50 Friday, Saturday and holiday eves.0.55 Haircut for children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday: a) before 5.00 p.m.0.30 b) after 5.00 p.m.0.40 Friday, Saturday and holiday eves.0.45 Cold wave, without additional charge for haircut, shampoo and water wave.8.00 Water wave.0.75 Shampoo.0.50\" 35.Section 84, subsection \"a\", is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of their work exceeding $25.00 per week\".36.Section 84, subsection \"b\" and \"c\", is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of his work exceeding double the wages earned.\" 37.Section 88, subsection \"«\" is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of their work exceeding $25.00 per week.\" 38.Section 88, subsection \"b'.' and \"c\", is amended by deleting the words: \"plus a 10% commission on the receipts of his work exceeding double the wages earned.\" 39.Section 89 is amended by reducing the price of \"the cold wave\" to $7.00.40.Section 93 is amended by substituting the following minimum prices for those now mentioned in the decree for the services enumerated hereunder: \"Haircut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Fridav.$0.60 2040 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Samedi et veilles de fêtes chômées.0.65 Coupe de cheveux pour enfants au-dessous de 14 ans: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.0.40 Samedi et veilles de fêtes chômées.0.45 41° L'article 94 est amendé en ajoutant les municipalités de village d'East-Broughton et d'East-Broughton Station.42° A l'article 97, les prix minima établis pour la coupe des cheveux des adultes sont remplacés par les suivants: Lundi, mardi, mercredi et jeudi.$0.55 Vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées.0.65\" et les mots \"indéfrisable ordinaire\" sont remplacés par les mots \"indéfrisable électrique\".43° La paragraphe \"o\" de l'article 100 est abrogé et remplacé par le suivant: \"a) avoir 16 ans révolus et ne pas dépasser 35 ans et avoir terminé sa neuvième année d'études dans les zones I et II, et sa huitième année d'études dans les autres zones.Cependant l'école peut admettre à l'apprentissage les candidats qui ne possèdent pas les qualifications relatives à la scolarité exposées ci-dessus, pourvu qu'ils 1° s'engagent par écrit au comité paritaire à ne pas exercer leur métier dans le territoire protégé par le présent décret; 2° se conforment aux cotions fixées par le décret régissant la pratique du métier dans la région où ils veulent l'exercer; 3° aient terminé au moins la septième année d'études s'ils désirent exercer le métier dans une région non contrôlée par un décret\".44° L'article 113 est remplacé par le suivant: \"113° Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 1er mai 1956.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 1er mai de l'année 1956 ou de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 40209-o Greffier du Conseil Exécutif.Chartes \u2014 Abandon de Dainty Apparel Inc.Avis est, par les présente», donné que la compagnie \"Dainty Apparel Inc.\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 15e jour de juin 1955.Le Secrétaire, 40196 ELLA BERNSTEIN.Hays Securities Corporation Limited Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Hays Securities Corporation Limited\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège Saturday and holiday eves.0.65 Haircut for children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.0.0 Saturday and holiday eves.0.45 41.Section 94 is amended by adding the village municipalities of East-Broughton and East-B rough ton Station.42.In section 97, the minimum prices established for adults' haircuts are replaced by the following: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.$0.55 Friday, Saturday and holiday eves.0.65\" and the words \"ordinary permanent wave\" are replaced by the words \"electric permanent wave\".43.Subsection \"a\" of section 100 is deleted and the following substituted therefor: \"a) be 16 years of age and not more than 35 and have completed his ninth year of study in zones I and II, and his eighth year of study in the other zones.However, the school may admit candidates who do not have the school qualifications above mentioned providing: 1.they agree, in writing, not to ply their trade in the territory covered by the present decree; 2.they abide by the conditions determined by the decree regulating the plying of the trade in the region where they intend work; 3.they have completed the seventh year of study when they intend to ply their trade in a territory not covered by a decree.\" 44.Section 113 is replaced by the following: \"113.Duration of the decree: The present decree remains in force until May 1st, 1956.It then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary, within the period extending from the sixtieth to the thirtieth day before May 1st of the year 1956 or of any subsequent year.Such a notice shall also be given to the Minister of Labour.\" (Document \"A\" annexed to the order).L.DÉSILETS, 9 40209-o Clerk of the Executive Council.Charters \u2014 Surrender of Dainty Apparel Inc.Notice is hereby given that \"Dainty Apparel Inc.\", incorporated under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 15th day of June, 1955.ELLA BERNSTEIN, 40196-o Secretary.Hays Securities Corporation Limited Notice is hereby given that \"Hays Securities Corporation Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2041 social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 27e jour de juin 1955.Le Secrétaire-trésorier, 40210 P, J.CREWE.Avis est par les présentes donné que \"Southwestern Furs of Canada Ltd.\", s'adressera au Procureur Général et au Ministre des Affaires Municipales de l'Industrie et du Commerce pour la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 31 mars 1955.Le Procureur de Southwestern Furs of Canada Ltd., PHILIP S.GARONCE, 40205-o 1449 rue St.Alexandre, Montréal.Su perm a de Hosiery Co.Ltd.AVIS Conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies de Québec, la Compagnie \"Super-made Hosiery Co.Ltd.\", donne par les présentes avis qu'elle s'adressera au Lieutenant-Gouverneur pour lui demander la permission d'abandonner sa charte et obtenir son annulation a compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Montréal, le 23 juin 1955.Le Président, 40206-o (Sig.) H.GROSSINGER.Arthur Dumas, Inc.Avis est donné que la compagnie susmentionnée dont le siège social est à St-Pamphile, conté de l'islet, Que., demandera la permission d'abandonner sa charte en vertu de l'article 26 de la \"Loi des Compagnies de Québec\".St-Pamphile', le 23 juin 1955.Le Procureur de \"Arthur Dumas, Inc.\", JOS.MARINEAU, avocat, 40207-o Montmagny, Que.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.404-55) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Criterion Advertising Company, Inc.\", a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères S.R.Q.1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la Province est à 214 ouest, rue St-Jacques, A/S de Hyde & Ahem, Esqs., Montréal, district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans toutes poursuites prises contre elle, est M.George Beverly Puddicombe, C.R., de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 28e jour de juin 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 40189 JEAN BRUCHÉSI.the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal this 27th day of June, 1955.P.J.CREWE, 40210-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that \"Southwestern Furs of Canada Ltd.\", will make application to the Attorney General and to the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, for leave to surrender its Charter.Montreal, March 31st, 1955.PHILIP S.GARONCE, Attorney for Southwestern Furs of canada Ltd., 40205-o 1449 St.Alexander Street, Montreal.Supermade Hosiery Co.Ltd.NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Supermade Hosiery Co.Ltd.\", hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor for acceptance of the surrender of its charter and its cancellation on and from a date to be fixed by him.Montreal, June 23rd, 1955.(Sgd) H.GROSSINGER, 40206-o President.Arthur Dumas, Inc.Notice is given that the abovementioned company, whereof the head office is at St.Pamphile, County of l'islet, Que., shall request leave to surrender its charter in accordance with section 26 of the \"Quebec Companies' Act\".St.Pamphile, June 23, 1955.JOS.MARINEAU, Advocate, Montmagny, Que., 40207 Attorney for \"Arthur Dumas, Inc.\".Company Licensed to do Business (P.Sec.404-55) Notice is hereby given that \"Criterion Advertising Company, Inc.\", has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies'Act, R.S.Q.1941, chapter 279.The principal office of the said Company in the Province is at 214 St.James Street West, c/o Hyde & Ahem, Esqs., Montreal, judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.George Beverly Puddicombe, Q.C., of the said City of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 28th day of June, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 40189-o Assistant Provincial Secretary. 2042 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Compagnies dissoutes (P.G.12759-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Four Seventeen St.Peter Street Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 31 janvier 194(5.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-0 C.E.CANTIN.(P.G._ 11436-55) Avis est donné qu'en vertu de la deuxième partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 127, et sujet à la responsabilité dédété par l'article 128 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de ha charte fie la compagnie \"Thomas Robertson & Company Limited\", constituée en corporation par la Loi 60 Victoria, chapitre 85, du 9 janvier 1897, de la Législature de la province de Québec, telle qu'amendée par la Loi 8, Ed.VII, chapitre 121, du 14 avril 1908.Avis est de plus donné qu'à compter du premier juin 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40189-o C.E.CANTIN.Companies Dissolved (A.G.12759-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Four Seventeen St.Peter Street Ltd.\", incorporated by letters patent dated January 31, 1946.Notice is also given that from and after the first day of June 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this June twenty-third 1955.C.E.CANTIN, 40189 Deputy Attorney General.(A.G.11430-55) Notice is hereby given that under Part II of the Quebec Companies' Act, section 127, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 12S of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Thomas Robertson & Company Limited\" incorporated by Act 60.Victoria, chapter 85.dated January 9.1897, of the Legislature of the Province of Quebec, as amended by Act 8, Ed.VII, chapter 121, dated April 14, 1908.From and after the first day of June 1955 the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third dav of June 1955.C.E.CANTIN, 401S9 Deputy Attorney General.Département des Affaires municipales Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 6 juin 1955 du conseil municipal de Lac-des-Écorces, comté de Labclle, et conformément aux dispositions du Code municipal, il a décrété, en date du 22 juin 1955, que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la dite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se feront, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en vertu de l'article 131 du Code municipal (10 George VI, ch.55, sec.2).Le 22 juin 1955.Le Ministre des Affaires municipales, 40190-o YVES PRÉVOST, C.R.Département de l'Instruction Publique N° 1295-54.Québec, le 21 juin 1955.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Pointe du Lac N° 2, dans le comté de St-Maurice, les lots 56 et 57 du cadastre officiel de Pointe du Lac, pour les annexer à la municipalité scolaire du village de Pointe du Lac, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40184-25-2-o O.J.DÉSAULNIERS.Department of Municipal Affairs The undersigned gives notice that as requested by resolution dated June 6th, 1955, of the Village municipal Council of Lac-des-Écorces, County of Labelle, and pursuant to the provisions of the municipal Code, he has decreed on June 22, 1955 that publication of any public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, except those required to be made in the Quebec Official Gazette, shall be made hereafter in the French language only.This notice is published in accordance with article 131 of the municipal Code (10 George VI, chapter 55, section 2).June 22, 1955.YVES PRÉVOST, Q.C., 40190 Minister of Municipal Affairs.Department of Education No.1295-54.Québec, June 21, 1955.Application is made to detach from the school municipality of Pointe du Lac No.2, in the county of St-Maurice, lots 56 «and 57 of the official cadastre of Pointe du Lac, to annex them to the school municipality of the village of Pointe du Lac, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 40184-25-2 Superintendent of Education, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2043 N° 519-51.Québec, le 27 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en (late du 15 juin 1955, de détacher de la municipalité scolaire de St-Gabricl-de-Brandon paroisse, dans le comté de Berthier, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de St-Gabriel-de-Brandon village.Ce territoire comprend partie des lots 530 et 537 du rang V du canton Brandon et est décrit comme suit, savoir: \"Partant d'un point situé à l'intersection des lots nos 530-A et 537 à la rue Dequoy, se dirigeant vers le nord-ouest sur une distance de 3S3 pieds et vingt-trois centième (383.23); de là vers le nord-est, une distance de trois cent quatre-vingt-six pieds et soixante-seize centièmes (38(5.70); de là vers le nord-ouest une distance de mille quatre cent vingt pieds (1,420); de là vers le sud-ouest, une distance de cinq cent quarante-six pieds et soixante-seize centièmes (54(5.7(5); de là vers le sud-est, une distance de mille sept cent quatre-vingt-dix pieds et douze centièmes (1,790.12) et de là vers le nord-est, une distance de cent soixante pieds (1(50) au point de départ, borné vers le nord-est respectivement par l'ancien chemin de St-Damien et les lots nos 530 partie et 536-A, vers le sud-est respectivement par une partie du lot no 536 et la rue Dequoy, vers le sud-ouest par une partie du lot no 537 et vers le nord-ouest- par des parties des lots nos 536 et 537 contenant en superficie dix-neuf acres et cent onze centièmes (19.111) mesure anglaise.' Cet arrête ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique.40199-o O.1.DÉSAULNIERS.N° 182-54.Québec, le 23 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, de détacher de la municipalité scolaire d'Inver-ness, dans le comté de Mégantic, les lots 441 à 446 inclusivement du rang VII du cadastre d'Inverness et les lots 34S à 353 inclusivement du rang VI du même cadastre, pour les annexer pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de ,St-Jean-de-Brébcuf.dans le même comté.De détacher de la municipalité scolaire d'Inverness, comté de Mégantic.la demie sud-ouest du lot no 299 du cadastre officiel d'Inverness, appartenant à M.Joseph Champagne, pour l'annexer pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de St-Jcan-de-Brcbeuf, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.\u2022 Le Surintendant de l'Inst ruction publique, 10199-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 627-55.Québec, le 27 juin 1955.Demande est faite d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, le territoire actuel de la municipalité scolaire protestante du canton de Granby à la municipalité scolaire protestante de la cité de Granby.Le Surintendant de l'Instruction publique.40213-26-2-o O.J.DÉSAULNIERS.No.519-51.Quebec, June 27th.1955.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 15th.1955.has been pleased to detach from the school municipality of St-Gabriel-de-Brandon, parish, in the county of Berthier, the territory here-inunder described to annex it to the school muni-ciplaity of St-Gabriel-de-Brandon village.This territory is comprised of part of lots 536 and 537 of range V of the township of Brandon and is described as follows, to wit: \"Starting from a point situate at the intersection of lots Nos.536-a and 537 on Dequoy Street, going in a northwesterly direction upon a distance of three hundred and eightv-threc feet and twenty-three hundredths (383.23); thence, to the northeast, for a distance of three hundred and eighty-six feet and seventy-six hundredths (3S6.76); thence, towards the northwest for a distance of one thousand four hundred and twenty feet (1,420) thence, towards, the southwest, for a distance of five hundred and forty-six feet and seventy-six hundredths (546.76) thence, towards the southeast at a distance of one thousand seven hundred and ninety feet and twelve hundredths (1,790.12) and thence towards the northeast, for a distance of one hundred and sixty feet (1(50) to the starting point, bounded on the northeast respectively by the old St-Damien road and lots Nos.530 partly, and 536-A,towards the southeast respectively by a part of lot No.536 and Dequoy Street, on the southwest by a part, of lot No.537 and on the northwest by parts of lots Nos.536 and 537.containing in superficial area nineteen acres and one hundred and eleven hundredths (19.111) English measure.\" This Order in Council has taken effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.182-54.Quebec.June 23th, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated June 15th, 1955, to detach from the school municipality of Inverness, in the county of Megantic.lots 441 to 440 inclusively of range VII of the cadastre of Inverness, and lots 348 to 353 inclusively of range VI, same cadastre, to annex them for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of St-Jean-de-Brébeuf, in the same county.To detach from the school municipality pf Inverness, county of Megantic, the southwest half of lot No.299 of the official cadastre of Inverness, belonging to Mr.Joseph Champagne, to annex it for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of St-Jean-de-Brébeuf,.in the same county.This Order in Council shall take effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.627-55.Quebec.June 27th, 1955.Application is made to annex, for Protestant ratepayers only, the actual territory of the Protestant school municipality of the township of Granby to the Protestant school municipality of the city of Granby.O.J.DÉSAULNIERS, 40213-26-2 Suprintendent of Education. 2044 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 N° 1317-54.Québec, le 18 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 8 juin 1955, d'annexer au territoire de la municipalité scolaire du village de Nominingue.dans le comté de Labelle, le territoire actuel de la municipalité scolaire du Canton Loranger, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 304-55.Québec, le 17 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 8 juin 1955, de détacher de la municipalité scolaire de Shipton, dans le comté de Richmond, les lots 10 à 13-V inclusivement et 14 à 28 inclusivement du rang III du cadastre officiel du Canton de Shipton, pour les annexer pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de la Ville de Richmond.Cet arrêté ministériel prendra effet le 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publiq e, 40199-O O.J.DÊSAULND2RS.N° 337-55.Québec, le 27 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, d'annexer, pour les contribuables catholiques seulement, le territoire actuel de la municipalité scolaire de Lac Lacroix, dans le comté de Pon-tiac, à la municipalité scolaire de Dorion, dans le même comté.Cet arrêté ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 45-55.Québec, le 15 juin 1955.\u2022 Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Joseph, dans le comté de Richelieu, à la municipalité scolaire de Filiatrault, même comté.Cet arrêté ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-O O.J.DÉSAULND3RS.N° 506-53.Québec, le 27 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus, dans le comté de Stanstead, le lot 582 et la partie du lot 581 du rang VIII du canton de Stanstead, appartenant à monsieur Leopold Lussier, pour les annexer à la municipalité scolaire de Sacré-Cœur-de-Jésus village, dans le même comté.Cet arrêté ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 428-54.Québec, le 27 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, de No.1317-54.Quebec, June 18, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, has been pleased, by Order in Council dated June 8, 1955, to annex to the territory of the School Municipality of the Village of Nominingue, in the County of Labelle, the present territory of the School Municipality of the Township of Loranger, in the same county.This Order in Council shall take effect on July 1st., 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.304-55.Quebec, June 17, 1955.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated June 8, 1955, has been pleased to detach from the School Municipality of Shipton, in the county of Richmond, lots 10 to 13-A inclusive, and 14 to28 inclusive, range VIII of the official cadastre of the township of Shipton, in order that they be annexed, for catholic ratepayers only, to the School Municipality of the town of Richmond.This order in Council will take effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.337-55.Quebec, June 27th, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated June 15th, 1955, to annex, for Catholic ratepayers only, the actual territory of the School municipality of Lac Lacroix, in the county of Pontiac, to the School municipality of -Dorion, same county.This Order in Council came into effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNEERS, 40199 Superintendent of Education.No.45-55.Quebec, June 15, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated June 15, 1955, to annex the actual territory of the School Municipality of St.Joseph, in the County of Richelieu, to the School Municipality of Filiatrault, same County.This Order in Council came into effect on July 1st., 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.506-53.Quebec, June 27, 1955.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 15, 1955, has been pleased to detach from the school municipality of the parish of \"Sacré-Cœur-de-Jésus\", in the county of Stanstead, lot 582 and that part of lot 581, range VIII, township of Stanstead, belonging to Mr.Leopold Lussier, to annex them to the school municipality of the \"Sacré-Cœur-de-Jésus\" village, in the same county.This Order in Council has taken effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULND3RS, 40199 Superintendent of Education.No.428-54 Quebec, June 27, 1955.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 15, 1955, has QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1966, Vol.87, No.26 2045 détacher de la municipalité scolaire de St-Théo-dore, dans le comté de Bagot, les lots 487, 488, 490, 491 et 499 du cadastre officiel de la paroisse de St-Théodore-d'Acton, pour les annexer à la mu-municipalité scolaire de la paroisse de St-André-d'Acton, dans le même comté.Cet arrêté ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 182-54.Québec, le 23 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, de détacher de la municipalité scolaire de Cham-hlv paroisse, dans le comté de Chambl.v, les lots nos 68, 69, 282, 487 et 489 du cadastre officiel de la paroisse de St-Basile-le-Grand, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Basile-lc-Grand, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 915-54.Québec, le 27 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Jérôme no 4 dans le comté des Deux-Montagnes, aux municipalités scolaires de Ste-Monique, même comté, et de St-Antoine-des-Laurentides dans le comté de Terrebonne, respectivement comme suit: 1.A la municipalité de St-Antoine-des-Lau-rentides, dans le comté de Terrebonne, un territoire faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de St-Jérôme et comprenant les lots 1 à 9 inclusivement de la Côte St-Georges et 92, 93 à 101 inclusivement de la concession des Prairies.2.A la municipalité scolaire de Ste-Monique, dans le comté des Deux-Montagnes, les lots 1 à 39 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de St-Jérôme.Cet arrêté ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1033-54.Québec, le 27 juin 1955.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 15 juin 1955, de détacher de la municipalité scolaire de St-Christophc-d'Arthabaska, dans le comté d'Ar-thabaska, le lot n° 3 du rang I du canton Arthabaska, pour l'annexer à la municipalité scolaire de Ste-Victoire Paroisse, dans le même comté.Cet arrêté ministériel a pris effet au 1er juillet 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, 40199-o O.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal (maintenant partie de la ville de Montréal ouest) division d'enregistrement de Montréal.been pleased to detach from the school municipality of St-Théodore, in the county of Bagot, lots 487, 488, 490, 491 and 499 of the official cadastre of the parish of St-Théodore-d'Acton, to annex them to the school municipality of the parish of St-André-d'Acton, in the same county.This Order in Council has taken effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.182-54.Quebec, June 23, 1955.His Honour, the Lieutenant-G>vernor in Council, by Order in Council, dated June 15, 1955, has been pleased to detach from the school municipality of Chambly parish in the countv of Chambly, lots Nos 68, 69, 282, 487 and 489 in the official cadastre of St-Basile-le-Grand, parish, to annex them to the school municipality of St-Basile-le-Grand, in the same county.This Order in Council will take effect on Julv 1st 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.915-54.Quebec, June 27, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Ordre in Council dated June 15, 1955, to annex the actual territory of the School Municipality of St.Jérôme No.4, in the County of Two Mountains, to the School Municipalities of St.Monique, same county, and St.Antoine-des-Laurentidcs, in the County of Terrebonne, respectively, as follows: 1.To the Municipality of St.Antoine-des-Laurentides, in the County of Terrebonne, a territory forming part of the official cadastre of the Parish of St.Jérôme and including lots 1 to 9 inclusive of Côte St.Georges and 92, 93 to 101 inclusive of des Prairies Concession.2.To the School Municipality of St.Monique, in the County of Two Mountains, lots 1 to 39 inclusive of the official cadastre of the Parish of St.Jérôme.This Order in Council came into effect on July 1st., 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.No.1033-54.Quebec, June 27, 1955.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated June 15, 1955, has been pleased to detach from the School Municipality of St.Christophe d'Arthabaska, in the county of Arthabaska, lot No.3 ,range I, of the township of Arthabaska, in order that it be annexed to the School Municipality of St.Victoire parish, in the same county.This Order in Council has taken effect on July 1st, 1955.O.J.DÉSAULNIERS, 40199 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the municipality of the parish of Montreal (now part of the town of Montreal West) registration division of Montreal.; 204g GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1965, Tome 87, N° 26 Avis est par la présente donné que les lots 138-300 à 138-390, 138-452 à 138-544, 138-546 à 138-660 et partie des lots 138-445 (rue).138-661, 138-602, 138-663, 138-778 (rue) et 138-305 (nie) sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 juin 1955.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-Ministre, 40191-o A VILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Cliarlesbourg (Ville de Cliarlesbourg) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 277-174 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 17 mai 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 40191-o A VILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la cité de Québec quartier St-Roch division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 11 est amendé et le lot 4481 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 16 juin 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 40191-o AVILA BÉDARD.Notice is herebv given that lots 138-306 to 138-396, 138-452 to 138-544, 138-546 to 138-660 and part of lots 138-445 (Street), 138-661, 138-662, 138-663, 138-778 (Street) and 138-305 (Street) are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, June the 20th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 40191 -o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of parish of Cliarlesbourg (Town of Cliarlesbourg) registration division of Quebec.Notice is hereby given that lot 277-174 has been cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May 17, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 40191-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the city of Quebec St.Roch Ward Registration division of Quebec.Notice is hereby given that lot 11 is amended and lot 4481 has been added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, June the 16th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 40191-o Deputy Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foy ville de Ste-Foy Division (l'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 292-64 à 292-70, 294-2 à 294-4 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 17 mai 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 40191-O AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Ste-Foy town of Ste-Foy Registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 292-04 to 292-70, 294-2 to 294-4 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, May 17, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 40191-o Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux établissements commerciaux dans les villes de Dolbeau et Mistassini et un rayon de trois (3) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret numéro 621 du 20 mai 1953, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret: Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the collective agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to commercial establishments in the towns of Dolbeau and Mistassini and a radius of three (3) miles from their limits, rendered obligatory by the decree number 621 of May 20, 1953, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2047 1° Le paragraphe \"g\" de l'article I sera remplacé par le suivant: \"g) Les mots \"teneur de livres\" et \"assistant-comptable\" désignent tout salarié qui accomplit un travail analogue à celui du comptable, tel que défini ci-dessus, mais qui n'est pas en charge.\" 2° Le paragraphe \"c\" de Partiel IV sera bitte.3° Les paragraphes 3° et 4° de l'article V seront remplacés par les suivants: \"3° En tout temps, une heure et quart doit être accordée aux salariés pour le repas du midi et une heure pour le repas du soir, les jours où ils sont appelés à travailler dans la soirée.\" \"4° L'employeur peut faire travailler ses employés jusqu'à 9.00 p.m.sans rémunération supplémentaire, les trois (3) jours ouvrables précédant Noël, soit les 22, 23 et 24 décembre, ainsi que la veille du Premier de l'An, soit le 31 décembre.\" 4° L'article VII sera remplacé par le suivant: \"VIL Jours de fêtes chômes: Les jours de fête suivants doivent être chômés et payés: Les dimanches, le Premier de l'An, le lendemain du Premier de l'An, l'Epiphanie, le lundi de Pâques, l'Ascension, le 24 mai (fête de Dollard), la St-.Iean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, la Toussaint, l'Immaculée-Conception, le jour de Noël et le lendemain du jour de Noël.Si la fête tombe un vendredi ou un samedi, elle sera remise au lundi suivant excepté si la fête est fêtée.Si la fête tombe un mardi, elle sera remise au lundi précédent excepté si la fête est fêtée.\" 5° L'article VIII sera remplacé par le suivant: \"VIII.Taux de salaires: Les salaires minima suivants doivent être payés: Salaires hebdomadaires Catégorie: hommes femmes Gérant.S75.00 Gérant adjoint.55.00 40.00 Chef du personnel.50.00 35.00 Chef de département ou 1er commis.50.00 35.00 Chef d'allée.40.00 28.00 Comptable.50.00 35.00 Teneur de livres et assistant-comptable, même taux que les commis.Sténo et sténo-dactylo: 1ère année.25.00 23.00 2ème année.30.00 28.00 3ème année.35.00 33.00 Employé de bureau, même taux que les commis Percepteur et solliciteur à commission : 1 ère année.30.00 2ème année.35.00 3ème année.40.00 4ème année.45.00 Les solliciteurs et vendeurs à commissions ne sont pas tenus responsables des ventfes approuvées par l'employeur ou son gérant.Commis: 1er semestre.20.00 17.00 2ème semestre.25.00 18.00 2ème année.28.00 20.00 3ème année.30.00 25.00 4ème année.38.00 1 /3-A 28.00 1/3-B 30.00 1/3-C 32.00 1.Subsection \"g\" of section I will be replaced by the following: \"g) The words \"bookkeeper\" and assistant-accountant\" mean any employee who does work similar to that of an accountant, but who is not in charge.2.Subsection \"c\" of section IV will be deleted.3.Subsections 3.and 4.of section V will be replaced by the following: \"3.One hour and fifteen minutes shall always be granted to employees for the noon meal and another hour for the evening meal, when they are required to work in the evening.4.The employer may keep his employees to work until 9.00 p.m.without extra pay on the three (3) days preceding Christmas (December 22, 23 and 24) and on New Year's eve (December 31).4.Section VII will be replaced by the following: \"VII.Feast days kept as holidays: The following shall be holidays with pay: Sunday, New Year's Day, the day after New Year's Dav, Epiphany, Easter Monday, Ascension Day, May 24 (Dollard Day), St.John the Baptist Day, Dominion Day (July 1st), Labour Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day, Christmas Day and the day after Christmas Day.Should the holiday fall on a Friday or a Saturday, it shall be deferred until the following Monday (when it is not observed); should it fall on a Tuesday, it shall be given on the preceding Monday (when it is not observed).5.Section VIII will be replaced by the following: \"VIII.Wage rates: The following shall be the minimum wages: Weekly wages Category:\tMale\tFemale Manager.\t$75.00\t Assistant manager.\t55.00\t40.00 Head of Personal.\t50.00\t35.00 Departmental manager or\t\t head clerk.\t50.00\t35.00 Floor walker.\t40.00\t28.00 Accountant .\t50.00\t35.00 Bookkeeper and assistant-\t\t accountant: same rate\t\t as clerks\t\t Stenographer and steno-\t\t grapher and typist:\t\t \t25.00\t23.00 2nd year.\t30.00\t28.00 3rd year .\t35.00\t33.00 Office employee: same rate\t\t as clerks.\t\t Commission salesmen:\t\t \t30.00\t \t35.00\t 3rd year .\t40.00\t 4th year .\t45.00\t Commission salesmen shall not be responsable for sales approved by the employer of his manager.Clerk: 1st six months.20.00 17.00 2nd six months.25.00 18.00 2nd year.28.00 20.00 3rd year.30.00 25.00 4th year.38.00 1/3-A 28.00 1/3-B 30.00 1/3-C 32.00 2048 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juiUet 1965, Tome 87, N° 26 Sème année .1/3-A 40.00 1/3-B 45.00 1/3-C 50.00 Couturière: 1er semestre.2ème semestre.2ème année.Caissier, même taux que les commis: Boucher.55.00 Aide-boucher: 1er semestre.20.00 2ème semestre.25.00 2ème année.28.00 3ème année.35.00 4ème année.45.00 Livreur avec voiture ou camion : 1ère année.27.00 2ème année.32.00 3ème année.37.00 4ème année.42.00 Aide livreur sur voiture ou camion : 1ère année.20.00 2ème année.25.00 3ème année.30.00 4ème année.35.00 Livreur mineur: de 15 à 16 ans.16.00 de 17 à 18 ans.18.00 Livreur à bicyclette.18.00 La bicyclette et ses accessoires doivent être fournies par l'employeur qui doit également voir aux réparations.\" 6° L'article XIII sera remplacé par le suivant: \"XIII.Heures d'ouverture -pour les épiceries et les quincailleries: Nonobstant les dispositions de l'article XI, les employés d'épiceries et de quincailleries doivent commencer le travail à 8.00 a.m.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail-, Québec, le 2 juillet 1955.40209-o Proclamation Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.(L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: 5thyear 1/3-A 40.00 1/3-B 45.00 1/3-C 50.00 Seamstress: 20.00 1st six months.20.00 22.50 2nd six months.22.50 25.00 2nd year.25.00 Cashier: same rate as clerks.Butcher.55.00 Butcher's helper: 1st six months.20.00 2nd six months.25.00 2nd year.28.00 3rd year.35.00 4th year.-45.00 Delivery man with horse-drawn or motor vehicle: 1st year.27.00 2nd year.32.00 3rd year.37.00 4th year.42.00 Delivery man's helper, horse-drawn or motor .vehicle : 1st year.20.00 2nd year.25.00 3rd year.30.00 4th year .35.00 Under age delivery man: from 15 to 16 years of age.16.00\" from 17 to 18 years of age.18.000 Delivery boy with bicycle 18.00 The bicycle and its accessories shall be supplied by the employer and the latter shall also keep same in repair.\" 6.Section XIII will be replaced by the following: \"XIII.Opening hours in groceries and hardware stores: Notwithstanding the provisions of section XI.the starting time for grocery and hardware store employees shall be 8.00 a.m.\" \u2022 During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 2, 1955.40209-o Proclamation Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern, \u2022 Greeting. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, July 2nd, 1956, Vol.87, No.26 2049 PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU que le se-gênéral, ) crétaire «les com- C.E.Cantin.\\ missaircs dûment nom-' mes pour les fins de la section 2 du chapitre 308 des Statuts refondus de Québec 1941 (Loi des paroisses et fabriques), dans et pour le diocèse catholique romain de Chicoutimi, dans Notre Province de Québec, tel que canoniquement reconnu et érigé par les autorités ecclésiastiques, a, sous l'autorité desdits statuts, transmis au Lieutenant-gouverneur en conseil le décret de l'autorité ecclésiastique dudit diocèse, en date du 23 octobre 1953, érigeant en paroisse canonique le territoire ci-après décrit, sous le nom de \"paroisse de Saint-Félix-d'Otis\", dans le comté de Chicoutimi; Attendu que le secrétaire desdits commissaires a, de plus, transmis un certificat attestant qu'après la publication de ce décret et des avis requis, conformément aux dispositions desdits statuts, il n'a été déposé à son bureau, dans le délai accordé par la loi, aucune opposition à la reconnaissance dudit décret canonique pour les fins civiles; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret du 15 juin 1955, portant le numéro 607, Nous avons confirmé, établi et reconnu et, par les présentes, confirmons, établissons et reconnaissons les limites et bornes assignées par ledit décret canonique à la \"paroisse de Saint-Félix-d'Otis\".Tout le territoire du canton d'Otis, tel qu'érigé par la proclamation du 24 décembre 1869, y compris les ou partie des chemins, rivières, lacs, cour d'eau renfermés dans ses limites, borné au nord par la rivière Sagucnay, au sud-est par les cantons de Hébert et de Brébeuf, au sud-ouest par le canton de Fcrland et au nord-ouest par le canton de Bagot.Et Nous avons ordonné et déclaré et, par les présentes, ordonnons et déclarons que la \"paroisse de Saint-Félix-d'Otis\", dans le conté de Chicoutimi, décrite comme susdit, sera une paroisse pour toutes les fins civiles, en conformité des dispositions desdits status.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jour de juin en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatrième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 40189-o JEAN BRUCHÉSI.Sièges sociaux AVIS de SITUATION du SlÈGE SOCIAL Avis est, par les présentes, donné que \"La Compagnie du Bassin de Laprairie Ltée \u2014 The PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \"VWHEREAS that, the Se-Dcputy Attorney ) *V cretary of the Com-General.\\ missioners duly named for ( the purposes of section 2 of chapter 308 of the Revised Statutes of Quebec, 1941 (Parish and Fabrique Act), in and for the Roman Catholic diocese of Chicoutimi, in Our Province of Quebec, as canonically acknowledged and erected by the ecclesiastical authorities, has, under the authority of the said statutes, transmitted to the Lieutenant-Governor in Council the decree of the ecclesiastical authority of the said diocese, dated October 23rd, 1953, erecting into a canonical parish the territory hereinafter described, under the name of \"parish of Saint-Félix-d'Otis\", in the county of Chicoutimi; Whereas that the Secretary of the said Commissioners has, moreover transmitted a certificate attesting that after the publication of this decree and of the required notices, in conformity with provisions of the said statutes, there has not been deposited his office, within the delay granted by the law, no opposition to the acknowledgment of the said canonical decree for civil purposes; Consequently, upon the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree of June 15th, 1955, bearing number 667, We have confirmed, established and acknowledged and, by these presents, confirm, establish and acknowledged the limits and boundaries assigned by the said canonical decree to the \"parish of Saint-Félix-d'Otis\", as follows, to wit: All the territory of the township of Otis, as erected by the proclamation of December 24th, 1869, comprised therein the or part of the roads, rivers, lakes, water-courses enclosed within its limits, bounded on the north by the Saguenay River, on the southeast by the townships of Hébert and Brébeuf, on the southwest by the township of Ferland and on the northwest by the township of Bagot.And We have ordained and declared and, by these presents, order and declare that the \"parish of Saint-Félix-d'Otis\", in the county of Chicoutimi, described as above said, shall be a parish for all civil purposes, in conformity with the provisions of the said statutes., Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have rendered Our present letters patent and upon same have set the Great Seal of Our Province of Quebec; Witness: Our Right Trusty and Well beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D.D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.X Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this twenty-eighth day of June, in the year nineteen hundred and fifty-five of our Lord and the fourth year of Our Reign.Bv command, JEAN BRUCHÉSI, 40189 Under Secretary of the Province.Head Offices Notice of the Situation of the Head Office Notice is hereby given that \"La Compagnie du Bassin de Laprairie Ltée \u2014 The Laprairie 2050 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Laprairie Basin Company Ltd.\", une compagnie constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes accordées par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec le 12e jour de mars 1953, et ayant son siège social en la cité de Montréal, district de Montréal, a établi son bureau au N° 128 rue Elmslie, Montréal 32, Québec.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 7e jour de juin 1955.Le Président.40197 P.N.THOMSON.(P.C.10308-55) Lies Entreprises St-Jokkph Ltée Règlement spécial \"E\" Adopté par les directeurs et approuvé par les actionnaires le 10 mai 1955 et changeant le siège social de la compagnie de Granby à l'adresse ci-après indiquée: \"Il a été unanimement résolu que le bureau-chef de la compagnie, soit transféré, à partir de ce jour, au village de St-Joscph sur Yamaska, district de St-Hyacinthe, au N 1000 de la rue St-Louis.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 40198-0 A.QUENNEVILLE.Basin company Ltd.\", a company incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec\" on the 12th of March 1953, and having its head office in the city of Montreal, district of Montreal, has establihed its office at No.128 Elmslie street, Montreal 32, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 7th day of June 1955.P.N.THOMSON, 10197-o President.(A.G.10308-55) Les Entreprises St-Joseph Ltée Special By-Law \"E\" Adopted by the directors and approved by the shareholders May 10th.1955, and changing the locality of the head office of the Company from Granby to the address hereinafter indicated: \"It has been unanimously resolved that the head office of the Company shall be transferred, as from this day, to the Village of St.Joseph sur Yamaska, district of St.Hyacinthe, at No.1000 St.Louis Street.\" Certified true copv.A.QUENNEVILLE, 40198 Secretory.Ventes \u2014 Loi de faillite Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 16 (1955).\"En matière de faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: P.E.Authier Co.Ltée, Val d'Or, P.Q., débitrice, & Claude Perras, syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Désignation: Des lots tie terre situés à Val d'Or, connus et désignés comme étant les lots numéros deux cent trente-six, deux cent trente-sept, deux cent trente-huit, deux cent trente-neuf, deux cent quarante et deux cent quarante et un, de la subdivision du lot originaire numéro quatorze (14-236, 237, 238, 239, 240 et 241) aux plan et livre de renvoi officiels pour le canton de Bourlamaque, avec bâtisses dessus érigées.Sera vendu en vertu d'un jugement de La Cour Supérieure pour le district de Montréal, (En faillite) rendu le 10 juin 1955, à l'enchère publique suivant la loi, pour ladite vente avoir l'effet du décret à la porte de l'Église paroissiale, Notre-Dame du Rosaire de Fatima, à Val d'Or, VENDREDI LE VINGT-NEUVIÈME jour du mois de JUILLET 1955, à ONZE heures de l'avant-midi, heure avancée de l'est.Conditions: comptant.En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 2J^% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges d'adresser au soussigné.Daté à Montréal, le 16 Juin 1955.Le Svndic, Bureau de: CLAUDE PERRAS.Perras & Perras, syndics, 4 Notre-Dame, est, Montréal.40175-25-2-0 Sales \u2014 Bankrupcy Act Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.16 (1955).\"Sitting in Bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of: P.E.Authier Co.Ltée, Val d'Or, P.Q., debtor & Claude Perras trustee.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit: Designation: Lots of land situate at Val d'Or, known and designated as being lots numbers two hundred and thirty-six, two hundred and thirty-seven, two hundred and thirty-eight, two hundred and thirty-nine, two hundred and forty and two hundred and forty-one, of the subdivision of the original lot number fourteen (14-236, 237, 238, 239, 240 and 241) on the official plan and in the book of reference for the township of Bourlamaque.with buildings thereon erected.' Shall be sold, in accordance with a judgment of the Superior Court for the District of Montreal, (Sitting in Bankruptcy) rendered June 10, 1955, by public auction according to law, the said sale to have the effect of a sale by Sheriff, at the parochial church door Notre-Dame du Rosaire de Fatima, at Val d'Or.FRIDAY, JULY TWENTY-NINTH, 1955, at ELEVEN oclock in the forenoon, Eastern Daylight Saving Time.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the buyer shall pay Government rights of 2l/$% according to the law.For further information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, June 16, 1955.CLAUDE PERRAS, Office of: Trustee.Perras & Perras, trustees, 4 Notre-Dame Street, East, Montreal, P.Q.40175-25-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1965, Vol.87, No.26 2051 Canada, Province de Quebec, district de Quebec.Cour Supérieure, N° 5157 F.(En matière de Faillite).Dans l'affaire de l'actif de: Legend re Automobile Inc., garagiste, Corps politique et Incorporé, Route Trans-Canada, Montmagny, Que.débitrice.Avis est par les présentes donné que: MARDI le DIX-NEUF JUILLET 1955 à ONZE heures a.m.sera vendu par encan public, à la porte de l'église de la ville de St-Thomas de Montmagny, comté de Montmagny, l'immeuble ci-après décrit, savoir: a) Un terrain situé en la paroisse de St-Thomas de Montmagny, mesurant cent soixante et six pieds (166') dans la ligne nord, le long de la nouvelle route Trans-Canada, trois cent quarante pieds environ (340') dans les lignes nord-est et sud-ouest, et cent soixante et six pieds environ (166') dans la ligne sud: lequel terrain est borné au nord par la nouvelle route Trans-Canada, au nord est à Napoléon Ouellet, au sud-ouest à Thomas Founder, c'est-à-dire à une clôture qui s'y trouve et au sud par Thomas Founder, et est connu et désigné comme faisant partie du lot numéro cent quarante-trois (Ptie 143) du cadastre officiel de la Paroisse de St-Thomas de Montmagny, avec toutes les bâtisses dessus construites (Servant de garage et d'entrepôt) circonstances et dépendances.L'immeuble ci-haut décrit sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes qui peuvent exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux syndics soussignés, 111 Côte de la Montagne, Québec.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A, du code de procédure civile et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949.Cette Vente équivaut à la vente faite par le Shérif et conformément à un jugement rendu par Me Robert Côté, C.R.Régistraire des Faillites.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, le 14 juin 1955.Les Syndics, JOSEPH MARMETTE & MAURICE BOULANGER.Bureaux: 111 Côte de la Montagne, Québec, Que.4014C-24-2-o Canada, Province of Quebec, district of Quebec Superior Court, No.5157 F.(sitting in bankruptcy).In the matter of the assets of: Legendre Automobile Inc., garage-keeper, a body politic and corporate, Trans-Canada Highway, Montmagny, Que., debtor.Notice is hereby given that: TUESDAY, on JULY NINETEENTH, 1955, at ELEVEN o'clock a.m.shall be sold by public auction at the church door of the town of St-Thomas of Montmagny, county of Montmagny, the immoveable hereinafter described, to wit: a) A plot of land situate in the parish of St-Thomas of Montmagny, measuring one hundred and sixty-six feet (166') in\" its northern line, along the new Trans-Canada highway, approximately three hundred and forty (340') feet in the northeast and southwest lines, and one hundred and sixty-six feet (166') in the southern line: which plot of land is bounded on the north by the new Trans-Canada route, on the northeast by Napoléon Ouellet, on the southwest by Thomas Founder, that is to say by a fence to be found there and on the south by Thomas Founder, and which is known and designated as forming part of lot number one hundred and forty-three (Pt.143) of the official cadastre of the parish of St-Thomas of Montmagny, with all the buildings thereon erected (being used as a garage and warehouse) circumstances and dependencies.The immoveable above described shall be offered to the highest and last bidder, with ground# rents which may exist.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the undersigned trustees, 111 Mountain Hill, Quebec.This sale is carried out in accordance with articles 716, 717 and 719A of the Code of Civil Procedure and also with section 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale is equivalent to a sale by Sheriff, and in conformity with judgment rendered by Me Robert Côté, Q.C., Registrar for Bankruptcy.Conditions of payment : cash.Quebec, June 14th, 1955.JOSEPH MARMETTE & MAURICE BOULANGER, Trustees.Offices: 111, Mountain Hill, Quebec, Que.40140-14-2 Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 82 (1955).''En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Antoine Robidoux, cultivateur St-Louis de Bonsecours, Que., débiteur & J.Alexandre Dansereau, syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que les terrains suivants, savoir: Désignation: \"Un terrain situé en la paroisse de St-Louis borné au sud-ouest par le numéro 228, au nord-est par le lot N° 220, au nord-ouest par le lot N° 150, et au sud par la rivière Yamaska, mesurant en front un arpent et six perches sur 24 arpents de profondeur, contenant en superficie trente-huit arpents et quarante perches, et connu et désigné au cadastre officiel de la paroisse de St-Louis, comme étant le lot numéro deux cent vingt-sept (N° 227), avec toutes les bâtisses y érigées.Province of Quebec, district of Montrea', Superior Court, No.82 (1955).\"Sitting in Bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of: Antoine Robidoux, farmer, St-Louis de Bon-secours, Que.debtor & J.Alexandre Dansereau, Trustee\".NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following plots of land, to wit: Designation: \"A plot of land situate in the parish of St-Louis, bounded on the southwest by number 228, on the northeast, by lot No.220, on the northwest by lot No.150, and on the south by the Yamaska River, measuring in front an arpent and six rods by 2-1 arpents in depth, containing in superficial area thirty-eight arpents and forty rods, and known and designated in the official cadastre of the parish of St-Louis, as being lot number two hundred and twenty-seven (No.227), with all the buildings thereon erected. 2052 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Un autre terrain situé en la paroisse de St-Louis mesurant en front un arpent et demi (1^) de largeur sur vingt-quatre arpents (24) arpents de profondeur, borné au sud-ouest parle N° 227, au nord-est par la partie N° 226, au sud-est par la rivière Yamaskaet au nord-ouest par le N° 151, et connu et désigné au cadastre officiel d'enregistrement pour la paroisse de St-Louis comme étant le tiers du lot (N° 226) Deux cent vingt-six, avec toutes les bâtisses y érigées.\" Seront vendus, en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure pour le district de Montréal, en faillite, rendu le 21e jour de juin 1955, à l'enchère publique suivant la loi, pour ladite vente, avoir l'effet du décret forcé au terme du code «le procédures civiles à la porte de l'église paroisiale de la paroisse de St-Louis de Bonsecours comté de Richelieu, MERCREDI le 3e jour d'AOÛT 1955, à ONZE heures de l'avant-midi, heure avancée.Conditions: comptant.En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 2}4% conformément à la Loi.Pour autres renseignements, et cahier des charges, s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 22e jour de juin 1955.Le Syndic, J.ALEXANDRE DANSEREAU.Bureau à: 31 rue St-Jacques ouest, Montréal, Que.BE 3324.40211-26-2-o Another lot of land situate in the parish of St-Louis measuring in front an arpent and one-half (lj/->) in width by twenty-four arpents (24) in depth, bounded on the southwest by No.227, on the northeast by Part No.226, on the south-Cast, by the.Yamaska River and on the northwest by No 151, and known and designated in the official registration cadastre for the parish of St-Louis as being the third of lot (No.226) Two hundred and twenty-six; with all the buildings thereon erected.\" Shall be sold, in accordance with a judgment of the Superior Court for the District of Montreal, Sitting in Bankruptcy, rendered on the 21st day of June, 1955, by public auction according to law, the said sale to have the effect of a sale by Sheriff, on the terms of the Code of Civil Procedure, at the parochial church door of the parish of St-Louis of Bonsecours, county of Richelieu, WEDNESDAY, the THIRD dav of AUGUST, 1955, at ELEVEN o'clock in the forenoon, Daylight Saving Time.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the buyer shall pay Government rights of 2l/2% according to the law.For further information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this 22nd day of June, 1955.J.ALEXANDRE DANSEREAU, Trustee.Office at: 31 St.James Street, West, Montreal, Que., BE 3324.40211-26-2 Vente par licit at ion Sale by Licitation Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 347,374,'Dame Fernande Desmarchais et vir, demandeurs, vs David Desmarchais et al., défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, et rendu par l'Honorable Juge Stuart B.Ralston, le 25 avril 1955, dans une cause dans laquelle Dame Fernande Desmarchais, épouse commune en biens de Romuald Dubuc, domicilié et résidant au numéro 4027 de la rue Mentana, dans les cité et district de Montréal, et ce dernier, partie aux présentes, tant personnellement que comme chef de la communauté, et pour autoriser sadite épouse et l'y assister, en autant que besoin est, sont demandeurs, et David Desmarchais, personnellement, des cité et district de Montréal, et Daviof Desmarchais, susdit, en sa qualité d'exécuteur testamentaire; Berthe Desmarchais, épouse commune en biens de Zenon Nadon, et de ce dernier, partie aux présentes, tant personnellement que comme chef de la communauté, et pour autoriser sadite épouse et l'y assister, en autant que besoin est, des cité et district de Montréal, et Berthe Desmarchais, susdite, en sa qualité d'exécutrice testamentaire; Simonne Desmarchais, é-pouse commune en biens de Armand Meilleur (alias Jos.Best) et ce dernier, partie aux présentes, tant personnellement que comme chef de la communauté, et pour autoriser sadite épouse et l'y assister, en autant que besoin est, de Buffalo, État de New York, un des États-Unis d'Amérique; Automne Desmarchais, épouse commune en biens de Hormidas Sinotte, et ce Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.347,374, Dame Fernande Desmarchais et vir, Plaintiffs, vs David Des-marchais et al., defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is given that in virtue of a Judgment of the Superior Court sitting in Montreal, in the flistrict\" of Montreal, on April 25th 1955, in a case in which Dame Fernande Desmarchais, wife common as to property of Romuald Dubuc, and residing at 4027 Mentana Street, in the city and district of Montreal, and the latter, being party in the case, both personaly and as head of the community, and to authorize his said wife and to assist her, as need be, are plaintiffs, and David Desmarchais, personally, of the city and district of Montreal, and David Desmarchais, above-named, in his capacity as executor; Berthe Desmarchais, wife common as to property of Zenon Nadon, and the latter, being party in the case, both personnally and as head of the community, and to authorize his said wife and to assist her, as need be, of the city and district of Montreal, and Berthe Des-marchais, above-named, in her capacity as executrix; Simonne Desmarchais, wife common as to property of Armand Meilleur (alias Jos.Best) and the latter, being party in the case, both personally and as head of the community, and to authorize his said wife and to assist her, as need be, of Buffalo, in the State of New York, one of the United States of America; Antonine Desmarchais, wife common as to properts of Hormidas Sinotte, and the latter, being party in the case, both personally and as head of the community, and to authorize his said wife and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.26 2053 dernier, partie aux présentes, tant personnelle- to assist her, as need be, of the city and district ment que comme chef de la communauté et pour of Montreal; Clairette Desmarchais, wife judi-autoriser sadite épouse et l'y assister, en autant cially separated as to property of Alfred Hillman, que besoin est, des cité et district de Montréal; and the latter, being party in the case, and to Clairette Desmarchais, épouse judiciairement sé- authorize his said wife and to assist her, as need parce de biens de Alfred Hillman, et ce dernier, be, of the city and district of Montreal; Marcel partie aux présentes, et -pour autoriser sadite Desmarchais, of the city and district of Mont-épouse et l'y assister, en autant que besoin est, real; Jacqueline Desmarchais, wife separated as «les cité et district de Montréal; Marcel Desmar- to property by marriage contract of Albert chais, des cité et district de Montréal; Jacqueline Drolet, and the said Albert Drolet, to authorize Desmarchais, épouse contractucllement séparée his said wife to these presents and to assist de biens de Albert Drolet, et ledit Albert Drolet, her, as need be, of the city and district of Mont-pour autoriser son épouse aux fins des présentes real, are defendants, ordering the licitation of the et l'y assister, en autant que besoin est, des cité immoveable described as follows: et district de Montréal, sont défendeurs, ordonnant la licitation de l'immeuble désigné comme suit: Un emplacement situé en la ville de Notre- An emplacement situated in the town of Notre-Dame des Neiges, faisant partie du terrain por- Dame des Neiges, forming part of a land known tant le numéro vingt-cinq (Pt.25) sur le plan as number twenty-five (Pt.25) on the official et au livre de renvoi officiels du Village Incorporé plan and book of reference of the incorporated de la Côte des Neiges, contenant quarante-sept Village of Côte des Neiges, containing forty-pieds de front par cent trente-quatre pieds de seven feet in front by one hundred and thirty-profondeur dans sa ligne sud-est et cent trente four feet in depth in its south-east line and one et un pieds et deux pouces de profondeur dans hundred and thirty-one feet and two inches in sa ligne nord-ouest, le tout mesure anglaise et depth in its north-west line, all English measure plus ou moins, et étant borné: au côté sud-ouest and more or less, and being bounded: on the par une rue étant la subdivision numéro cin- south-west side by a street being sub-division quante-deux dudit lot numéro vingt-cinq, sur number fifty-two of said lot number twenty-five, ledit plan; au côté nord-est par une autre on the said plan; on the north-east side by another partie dudit lot numéro vingt-cinq sur ledit part of said lot number twenty-five on the said plan, appartenant à James Swail ou représen- plan, belonging to James Swail or his représentants; au nord-ouest par un emplacement faisant tatives; on the north-west by an emplacement partie dudit numéro vingt-cinq, occupé par Na- forming part of said number twenty-five, occupied poléon Groulx ou représentants, et au côté by Napoléon Groulx or his representatives, and -sud-est par le lot numéro dix desdits plan et on the south-east side by lot number ten of said livre de renvoi officiels du Village Incorporé de officiai plan and book of reference of the in-la Côte des Neiges et appartenant à l'Oeuvre.et corpoiated Village of Côte des Neiges and be-Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame de longing to the Oeuvre et Fabrique of the Parish Montréal, avec les bâtisses dessus construites of Notre-Dame de Montreal, with the buildings portant le numéro civique 5105 avec Decelles.thereon erected and bearing civic number 5105 of Decelles Avenue.L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'en- The above described immoveable will be sold chère et adjugé au plus offrant et dernier enché- by auction and adjudged to the highest and last risseur, le VINGT-SIX JUILLET 1955, à DIX bidder on the TWENTY-SIXTH of JULY 1955, heures et TRENTE de l'avant-midi, dans la salle at HALF past TEN o'clock in the forenoon, d'audience N° 31 au Palais de Justice à Mont- in Court Room No.31 in the Court House of réal, Cour tenante, sujet aux charges, clauses Montreal, the said sale to be made subject to et conditions indiquées dans le cahier des charges the charges, clauses and conditions mentioned in déposé au greffe du Protonotaire de ladite Cour, the list of charges filed in the office of the Protho-et que toute opposition afin d'annuler, afin de notary of the said Court.Any opposition to charges, ou afin de distraire à ladite licitation annul, to secure charges or to withdraw to be devra être déposée au greffe du Protonotaire de made to the said licitation must be filed in the ladite Cour au moins 12 jours avant le jour office of the Prothonotary of the said Court at fixé comme susdit pour la vente et adjudication least 12 days before the day fixed as aforesaid et que toute opposition afin de conserver devra for the sale and adjudication and any opposition être déposée dans les 6 jours après l'adjudication; for payment must be filed within six days follow-et à défaut par les parties de déposer lesdites ing the adjudication; and failing the interested oppositions dans les délais presents par les pré- parties to file the said opposition within the delays sentes, elles seront forecloses de droit de le faire, hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Un dépôt de $1,200.00 sera exigé avant la A deposit of $1,200.00 shall be exacted from vente de tout offrant ou enchérisseur.each and every bidder.Montréal, le 21 juin 1955.Le Procureur des demandeurs, 40177-25-2-O YVAN MERCURE.VENTES PAR SHERIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.Montreal, 21st June 1955.YVAN MERCURE, 40177-25-2-O Attorney for Plaintiffs.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below. 2054 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 ABITIBI Canada \u2014 Province de Québec District d'Abitibi Cour Supérieure, ( A RMAND FORTIN, mar-N° V-2497 < chand de Tiblemont, \\ district d'Abitibi, demandeur; vs JULES PERREAULT, colon de Tiblemont district d'Abitibi, défendeur.AVIS DE VENTE Les droits acquis sur les lots connus et désignés comme étant la demi nord de la demi est du lot numéro 43 et la demi nord du lot numéro 52 du rang 9 canton I'ascalis, avec bâtisses, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de Tiblemont le SAMEDI SEIZE JUILLET 1955 à DEUX heures de l'après-midi (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, 2 juin 1955.40081-23-2-O ABITIBI Canada \u2014 Province of Quebec District of Abitibi Superior Court, C A RMAND FORTIN, mer-No.V-2497 < a}- chant of Tiblemont, dis-( trict of Abitibi, plaintiff; vs JULES PERREAULT, settler of Tiblemont, district of Abitibi, defendant.NOTICE OF SALE The rights acquired on lots known and designated as being the north half of the east half of lot number 43 and the north half of lot number 52 of range 9, township of Pascalis, with buildings, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the church of Tiblemont, SATURDAY the SIXTEENTH day of JULY 1955, at TWO o'clock in the afternoon, (Daylight Saving Time).FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, June 2nd, 1955.40081-23-2 BEAUIIARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris Province de Québec \u2014 District de Beauharnois Cour Supérieure, ( t A CAISSE POPULAIRE N° 63 < j-/ STE-CÉCILE DE SA-{ LABERRY, demanderesse,vs L'INDUSTRIE LINIÈRE SALABERRY LIMITÉE, défenderesse.Saisis comme appartenant à ladite défenderesse : \"Les lots de terre désignés au cadastre officiel de la paroisse Ste-Cécile, district de Beauharnois, sous les numéros cent cinquante-ct-un et cent cinquante-deux de la subdivision du lot numéro quatre-vingt-quinze (95-151 et 152), avec bâtisses dessus construites.\" Pour être vendus au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la cité de Salaberry de Valleyfield, district de Beauharnois, le LUNDI VINGT-CINQ JUILLET, à ONZE heures de l'avant-midi.Salaberry de Valleyfield, ce 7 juin 1955.Le Shérif, 40082-23-2-O ERNEST POIRIER.IBERVILLE Canada \u2014 Province de Québec District d'Roerville Cour Supérieure, ( t A COMMISSION DU N° 42 (E.P.) < -L* PRÊT AGRICOLE CA-iNADIEN, corporation légalement constituée en vertu du chapitre 66 des Statuts revisés du Canada de 1927 et ayant son principal bureau dans la Province de Québec, dans la cité de Québec, requérante, vs ALCIDE DAOUST, de Valleyfield, dans le district de Beauharnois, intimé, Comme appartenant à l'Intimé, savoir: \"1° Un terrain de la contenance de cent vingt arpents en superficie, plus ou moins, situé dans la huitième concession, connu et désigné sous le»; lots numéro cinquante-deux et cinquante-trois (52 & 53) selon le cadastre officiel de la paroisse de Ste-Brigide, comté d'Iberville; 2° Un autre terrain situé dans la même concession de la contenance de soixante arpents en superficie, sans garantie de mesure précise, connu et désigné sous le lot numéro cinquante-et-un, BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris Province of Quebec \u2014 District of Beauharnois Superior Court, ( t A CAISSE POPULAIRE No.63 < ST.CÉCILE DE SALA-l BERRY, plaintiff, vs L'INDUSTRIE LINIÈRE SALABERRY LIMITÉE, defendant.Seized as belonging to said defendant : \"The lots of land designated on the official cadastre of the parish of St.Cécile, district of Beauharnois, under numbers one hundred and fifty-one and one hundred and fifty-two of the subdivision of lot number ninety-five (95-151 and 152), with buildings erected thereon.\" To be sold at the Sheriff's Office at the Court House, in the city of Salaberry de Valleyfield, district of Beauharnois, MONDAY, the TWENTY-FIFTH day of JULY 1955, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Salaberry de Valleyfield, this June 7th, 1955.ERNEST POIRIER, 40082-23-2 Sheriff.IBERVILLE Canada \u2014 Province of Quebec District of Iberville Superior Court, ( CANADIAN FARM LOAN No.42 (E.P.) < ABOARD,corporation legal-' ly incorporated under chapter 66 of the Revised statutes of Canada 1927 and having its principal office in the Province of Quebec, in the city of Quebec, petitioner, vs ALCIDE DAOUST, of Valleyfield, in the district of Beauharnois, respondent.As belonging to the respondent, to wit: \"1.A plot of land containing one hundred and twenty arpents in superficial area, more or less situate in the eighth concession, known and designated under lots number fifty-two and fifty-three (52 & 53) according to the official cadastre of the parish of Ste-Brigide, county of Iberville; 2.Another lot of land situate in the same Concession containing sixty arpents in superficial area, without guarantee of precise measurements, known and designated under lot number fifty- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1956, Vol.87, No.26 2055 (51) selon le cadastre officiel de la paroisse de Ste-Brigide, comté dTbcrville: Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances;\" Pour être vendue à la porte de l'église de Ste-Brigide JEUDI le QUATORZIÈME jour de JUILLET 1955, à ONZE heures de l'avant-midi Le Shérif, Bureau du Shérif, RICHARD MERCIER.Saint-Jean le 2 juin, 1955.40083-23-2-O JULIETTE Fieri Facias de Terris Province de Québec \u2014 District de Montréal ( our Supérieure, / t 'ORDRE IN D É P E N - N° 307,504.< -L* DANT DES FORES-\\ TIERS, corps politique et incorporé, ayant son siège social à Toronto, province d'Ontario, et une place d'affaires pour la province de Québec, en les cité et district de Montréal, demanderesse vs PAUL LA BRÈCHE, courtier d'assurances et d'immeubles, résidant et domicilié au 4999 de la rue Lafontaine, en les cité et district de Montréal, défendeur.Comme appartenant et étant en la possession du défendeur les biens immobiliers ci-après mentionnés et décrits, savoir: Un morceau de terre de forme irrégulière, situé dans la dite paroisse de Ste-Julienne, connu et désigné comme étant une partie du lot.de terre numéro cinq (P.5) des plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la dite paroisse de Ste-Julienne, avec bâtisses y érigées, lequel morceau de terre comprendrait tout le terrain se trouvant en dedans d'une ligne parlant d'un point situé sur le côté est du chemin de la Fourche à l'endroit où se trouve une clôture qui sépare le terrain présentement vendu et celui appartenant à M.Depairon, suivant cette clôture dans une direction est, à une distance d'environ 28S pieds, soit jusqu'à la rivière et suivant cette rivière jusqu'à une autre clôture qui la rejoint, tournant alors vers l'ouest en suivant le haut de la côte, jusqu'à un piquet vers le chemin public, à une distance d'environ 372 pieds, pour rejoindre le chemin, à une distance d'environ 108 pieds au nord de l'autre terre voisine appartenant à Dame Camille Éthier, et de là, vers le nord, en suivant le chemin public, jusqu'au point de départ; lequel morceau de terre est borné comme suit: en front, à l'ouest, par le chemin public; du côté nord, par M.Depairon et par la rivière et à l'est, au sud-est et au sud, par Dame Camille Éthier ou représentants.Ainsi que le tout se trouve actuellement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées à ce morceau de terre.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Ste-Julienne, comté de Montcalm, district de Joliette, le JEUDI, QUATRIÈME jour d'AOÛT 1955, à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, CAMILLE BONIN.Joliette, 27 juin 1955.40212-26-2-a QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: ( XTORMAN STERNLIEB N° 79,228 < -*-N & MAX CLARFELD, ' tous deux de la cité de Québec et y faisant affaires sous les nom et raison one, (51) according to the official cadastre of the parish of Ste-Brigide, county of Iberville: The whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies;\" To be sold at the church door of Ste-Brigide, THURSDAY, the FOURTEENTH day of JULY, 1955, at ELEVEN o'clock in the forenoon.RICHARD MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.Saint-John, June 2nd, 1955.40083-23-2 JOLIETTE Fieri Facias de Terris Province of Quebec \u2014 District of Montreal Superior Court, ( THE INDEPENDENT No.307.504.< 1 ORDER OF FORES-v TERS, a body politic and incorporated, having its head office at Toronto, Province of Ontario, and a business place for the Province of Quebec in the city and district of Montreal.Plaintiff vs PAUL LA BRÈCHE, insurance and real estate broker, residing and domiciled at -1999 Lafontaine Street, in the city and district of Montreal, Defendant.As belonging and being in the possession of the defendant the immoveable property hereinafter mentioned and described, to wit: A plot of land of irregular form, situate in the said parish of Ste-Julicnne, known and designated as being a part of a lot of land number five (Pt.5) on the official plan and in the book of reference of the cadastre of the said parish of Ste-Juliennc, with buildings thereon erected, which plot of land would be comprised of all the land to be found within a line starting from a point situate on the east side of the road from the Fork at the place where there is a fence which separates the land now sold and that belonging to Mr.Depairon, following this fence in an easterly direction, at a distance of about 288 feet, that is up to the river and following river, this as far as another fence which joins it, turning then to the west by following the height of the hill, to a post towards the public highway at a distance of about 372 feet to again join the road at a distance of about 108 feet north of the other neighboring farm belonging to Dame Camille Ethier, and thence, on the north, by following the public highway, to the starting point; which plot of land is bounded as follows: in front, on the west, by the public highway; on the north side, by Mr.Depairon and by the river and on the east, on the southeast and on the south, by Dame Camille Ethier or representatives.Such as the wdiole appears presently, with the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to this plot of land.To be sold at the church door of the parish of Ste-Julienne, county of Montcalm, district of Joliette, THURSDAY, the FOURTH day of AUGUST, 1955, at TWO o'clock in the afternoon.CAMILLE BONIN, Sheriff's Office, Deputv Sheriff.Joliette, June 27, 1955.40212-26-2 QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : ( XTORMAN STERNLIEB No.79,228 ^ IN & MAX CLARFELD, \\ both of the city of Quebec and carrying on business under the name and style 2056 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1956, Tome 87, N° 26 sociale de: SERVICE FINANCE CO.REG'D of: SERVICE FINANCE CO.REG'D at 37 à 37 de la Couronne, en les cité et district de Crown Street, in the city and district of Quebec, Québec, contre ROBERT ROULEAU, domicilié against ROBERT ROULEAU, domiciled at à 254 rue St-Olivier, en les cité et district de 254 St-Olivier Street, in the city and district of Québec, à savoir: Quebec, to wit: Une terre située à St-Êtienne de Lauzon, con- A farm situate at St-Etienne of Lauzon, recession Pétrée, contenant trois arpents de lar- tree concession, containing three arpents in geur sur vingt arpents de profondeur, connue et width by twenty arpents in depth, known and désignée sous le numéro trois cent soixante-sept designated under number three hundred and (367) aux plan et livre de renvoi officiels du ca- sixty-seven (367) on the official plan and in the dastre pour la paroisse de St-Étienne de Lauzon, book of reference of the cadastre for the parish comté de Levis, avec la maison dessus construite, of St-Étienne of Lauzon, county of Levis, with circonstances et dépendances.house thereon erected, circumstances and dependencies.Pour être vendu à la porte de l'église paroissia- To be sold at the parochial church door of St- le de St-Étienne de Lauzon, comté de Levis, le Etienne of Lauzon, county of Levis, on JULY VINGT-DEUX JUILLET prochain à DIX TWENTY-SECOND next at TEN o'clock in heures du matin (heure avancée).the forenoon (Daylight Saving Time).Le Député-Shérif, ALBERT F.RACETTE, Bureau du Shérif, ALBERT F.RACETTE.Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.Québec, 14 juin 1955.40137-24-2-o Quebec, June 14th, 1955.40137-24-2 [Première insertion: 18 juin 1955] [First insertion: June 18th, 1955] [Deuxième insertion: 2 juillet 1955] [Second insertion: July 2nd, 1955] RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski Cour Supérieure, ( t EVASSEUR & FRÈRE N° 17,103 < ¦L' INC., corps politique et \\ incorporé ayant son siège social à Matane, district de Rimouski, demanderesse vs GEORGES IMBEAULT, Poncheville, comté de Matane, district de Rimouski, défendeur.Un terrain ou emplacement situé dans la paroisse de St-Jérôme de Matane de forme irrégulière, mesurant cent quarante (140) pieds de front sur la route nationale, cent quarante-neuf (149) pieds dans sa ligne est, et trente-cinq (35) pieds dans sa ligne sud, cent quatre-vingt-six (186) pieds dans sa ligne ouest, borné au nord par l'ancienne route nationale, à l'est et au sud par la propriété de Valmont Imbeault et à l'ouest par celle d'Hector Bélanger, étant connu comme faisant partie du numéro cinquante-six (P.56) au cadastre officiel de la paroisse de St-Jérôme de Matane, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Rédempteur de Matane, le QUINZIÈME jour de JUILLET, 1955, à TROIS heures de l'après-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, JACQUES MARTIN.Rimouski, 7 juin 1955.40086-23-2-o RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada, Province of Quebec District de Rimouski Superior Court, / t EVASSEUR & FRÈRE No.17,103 < -L» INC., a body politic and \\ corporate, having its head office at Matane, district of Rimouski, plaintiff, vs GEORGES IMBEAULT, Poncheville, county of Matane; district of Rimouski, defendant.A lot of land or emplacement situate in the parish of St-Jérôme of Matane of irregular form, measuring one hundred and forty feet (140) feet in front on the National highway, one hundred and forty-nine (149) feet in its easterly line and thirty-five (35) feet in its southerly line, one hundred and eighty-six (186) feet in its westerly line, bounded on the north by the old National route, on the east and on the south by the property of Valmont Imbeault and on the west, by that of Hector Bélanger, being known as forming part of number fifty-six (Pt.56) on the official cadastre of the parish of St-Jérôme of Matane, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the parish of St-Rédempteur of Matane, the FIFTEENTH day of JULY, 1955, at THREE o'clock in the after-noon.JACQUES MARTIN, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.Rimouski, June 7, 1955.40086-23-2 TERREBONNE TERREBONNE Canada, Province de Québec \u2022 Canada, Province of Quebec District de Montréal District of Montreal Cour Supérieure, ( \"DDGAR PATENAUDE, gé- Superior Court, / \"DDGAR PATENAUDE, N° 363640 < *-* rant, des cité et district No.363640 < manager, of the city and '.de Montréal, demandeur, vs \\ district of Montreal, plaintiff, LOUIS MARTIN, des cité et district de Mont- vs LOUIS MARTIN, of the city and district of réal, défendeur, Montreal, defendant.\"Trois lots de terre connus et désignés sous \"Three lots of land known and designated under les numéros cent-trente-trois, cent-trente-quatre numbers one hundred and thirty-three, one hun- et cent trente-cinq de subdivision du lot origi- dred and thirty-four and one hundred andfthirty- naire numéro cent trente-trois (133-133-134 & five of the subdivision of original lot number one 135) des plan et livre de renvoi officiels de la hundred and thirty-three (133-133-134 & 135) of piroisse de St.Eustache, lesquels terrains sont the official plan and book of reference of the parish situés à North Pine Beach, avec les bâtisses des- of St.Eustache, which pieces of land are situated sus érigés.\" at North Pine Beach, with buildings erected thereon.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.20 2057 Pour être vendu à la porie de l'église catholique de la paroisse de St-Eustache, le TREIZIÈME jour de JUILLET 1955 à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif de Terrebonne, Bureau du Shérif, ALBERT FOURNELLE.Saint-Jérôme, ce 3 juin 1955.40084-23-2,o Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour de Magistrat ( pi HARLEMAGNE VIL-N° 15,560 < ^> LENEUVE, rentier do-\\ micilié à St-Joachim de la Plaine, district de Terrebonne, demandeur, vs RODOLPHE GARIÉPY, de St-Lin, des Lau-rentides, district de Terrebonne, défendeur.\"Une terre située à St-Lin en la côte St-Am-broise, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiel du cadastre de ladite paroisse sous les numéros 1942, 1943, 1944 et 1945 avec les bâtisses y érigées.A distraire du numéro 1942 la partie vendue et appartenant à la Commission scolaire de Saint-Lin.\" Pour être vendu à la porte de l'église catholique de St-Lin des Laurentides le TREIZIÈME jour de JUILLET 1955, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ALBERT FOURNELLE.Saint-Jérôme, ce 3 juin 1955.40085-23-2-o To be sold at the Catholic Church door of the parish of St.Eustache, the THIRTEENTH day of JULY 1955, at ELEVEN o'clock in the fore noon.ALBERT FOURNELLE, Sheriff's Office, Sheriff for Terrebonne.Saint-Jérôme, this June 3, 1955.40084-23-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Magistrate's Court (/^t HARLEMAGNE VIL-No.15,560 < LENEUVE, annui- v tant, domiciled at St.Joachim de la Plaine, district of Terrebonne, plaintiff, vs RODOLPHE G ARIÉPY, of St.Lin des Laurentides, district of Terrebonne, defendant.\"A farm situated at St.Lin on St.Ambroise Hill, known and designated on the official plan and book of reference of the cadastre of the said parish under numbers 1942, 1943, 1944 and 1945 with buildings erected thereon.Save, to be deducted from number 1942, that part sold and belonging to the School commission of Saint Lin.\" To be sold at the Catholic church door of St.Lin des Laurentides, the THIRTEENTH day of July 1955, at THREE o'clock in the afternoon.ALBERT FOURNELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Saint Jérôme, this June 3rd, 1955.40085-23-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N* 26 Action en separation de biens: McBain vs Rowell.2032 Action en séparation de corps et de biens: Patterson vs Zuck.2032 Arrêté en Conseil: 665-A \u2014 Métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec.2035 Réception des annonces: 1855 Avis aux intéressés: 2017 Avis divers: Chantier Coopératif de l'U.C.C.de Grande Baie (Fondation).____ 2033 Comité de Moralité Publique du Diocèse de St-Jean (Directeurs).2034 Coopérative d'Aqueduc de l'Anse au Griffon (Fondation).2033 Coopérative d'Électricité du Canton d'Iberville (Fondation).2033 La Caisse Populaire de St-Philippe de Montréal (Fondation).2035 Lakeside Heights Baptist Church (Demande d'incorporation).2032 L'Association des Camionneurs de la Région de Chicoutimi, Inc.(Formation) .2034 Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Cœur de' Montmagny Inc.(Directeurs).2033v Index of the Quebec Official Gazette, No.26 Action for Separation as to Property : McBain vs Rowell.2032 Action for Separation as to Bed and Board: Patterson vs Zuck.2032 Order in Council: 665-A \u2014 Men's and ladies' hairdressing trades in the district of Quebec.2035 Receipt of Advertising Copies: 1855 Notice to Interested Parties: 2017 Miscellaneous Notices:\" Chantier Coopératif de l'U.C.C.de Grande Baie (Foundation).2033 Comité de Moralité Publique du Diocèse de St-Jean (Directors).2034 Coopérative d'Aqueduc de l'Anse au Griffon (Foundation).2033 Coopérative d'Électricité du Canton d'Poerville (Foundation).2033 La Caisse Populaire de St-Philippe de Montréal (Foundation).2035 Lakeside Heights Baptist Church (Application for incorporation).2032 L'Association des Camionneurs de la Région de Chicoutimi, Inc.(Formation) .2034 Le Service d'Éducation du Collège .Sacré-Cœur de Montmagny 'Inc.(Directors).2033 2058 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1955, Tome 87, N° 26 Montreal Fluorescent Service Company (Directeurs).2034 Montreal Industrial Land Company Limited (Dist.de l'actif).2035 Syndicat des Travailleurs en Chaussures de l'Assomption, Incorporée (Changement de nom).2034 C h a rte8 \u2014 Abandon de : Arthur Dumas, Inc.2041 Dainty Apparel Inc.2040 Hays Securities Corporation Limited.2040 Southwestern Furs of Canada Ltd.2041 Supermade Hosiery Co.Ltd.2041 Compagnie autorisée à faire des affaires: Criterion Advertising Company, Inc.2041 Compagnies dissoutes: Four Seventeen St.Peter Street Ltd.2042 Thomas Robertson & Company Limited 2042 DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES: Affaires Municipales: Lac-des-Écorces, munie, de.2042 Montreal Fluorescent Service Company (Directors).2034 Montreal Industrial Land Company Limited (Dist.of the assets).2035 Syndicat des Travailleurs en Chaussures de l'Assomption, Incorporée (Change of name).2034 Charters \u2014 Surrender of: Arthur Dumas, Inc.2041 Dainty Apparel Inc.2040 Hays Securities Corporation Limited.2040 Southwestern Furs of Canada Ltd.2041 Supermade Hosiery Co.Ltd.2041 Company Licensed to do Business: Criterion Advertising Company, Inc.2041 Companies Dissolved: Four Seventeen St.Peter Street Ltd.2042 Thomas Robertson & Company Limited 2042 DEPARTMENTAL NOTICES: Municipal Affairs: Lac-des-Écorces, munie, of.2042 Instruction publique: Municipalité scolaire de: Dorion.2044 Filiatrault.2044 Granby, cité de.2043 Nominingue, village de.2044 Pointe du Lac, village de.2042 Richmond, ville de.2044 Sacré-Cœur-de-Jésus, village de.2044 St-André-d'Acton, paroisse de.2044 St-Basile-le-Grand.2045 Ste-Monique et al.2045 Ste-Victoire, paroisse de.2045 St-Gabriel-de-Brandon, village de.2043 St-Jean-de-Brébeuf.2043 Education: School Municipality of: Dorion.\u2022.2044 Filiatrault.2044 Granby, city of.2043 Nominingue, village of.2044 Pointe du Lac, village of.2042 Richmond, town of.2044 Sacré-Cœur-de-Jésus, village of.2044 St-André-d'Acton, parish of.2044 St-Basile-le-Grand.2045 Ste-Monique et al.2045 Ste-Victoi re.parish of.2045 St-Gabriel-de-Brandon, village of.2043 St-Jean-de-Brébeuf.2043 Terres et Forêts: Service du Cadastre: Charlesbourg, paroisse de.2046 Montréal, paroisse de.2045 Québec, cité de.2046 Ste-Foy, paroisse de.2046 Travail: Industrie ou métiers de: Établissements commerciaux dans les villes de Dolbeau et Mistassini (Modification).2046 Lettres patentes: Bouthillier Construction Limitée.2018 Brique St-Jean Ltée.2019 Capeco Limited.2019 Chez Capri Inc.2019 Cloutier & Frère Inc.2020 Czechoslovak Welfare Association.2020 D & B Sound and Signais Inc.2021 Dion & Frère Limitée.2021 Electrical Applicances Merchants Association \u2014 Association des Marchands d'Appareils Électriques.2021 Elk Investment Corp.2022 Eugène Bolduc Limitée.2022 Lands and Forest: Cadastral Branch: Charlesbourg, parish of.2046 Montreal, parish of.2045 Quebec, city of.2046 Ste-Foy, parish of .2046 Labour: Industry or Trades of: Commercial establishments in the towns of Dolbeau and Mistassini (Amendment) .2046 Letters patentes: Bouthillier Construction Limitée.2018 Brique St-Jean Ltée.2019 Capeco Limited.2019 Chez Capri Inc.2019 Cloutier & Frère Inc.2020 Czechoslovak Welfare Association.2020 D & B Sound and Signals Inc.2021 Dion & Frère Limitée.2021 Electrical Applicances Merchants Association \u2014 Association des Marchands d'Appareils Électriques.2021 Elk Investment Corp.2022 Eugène Bolduc Limitée.2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 2nd, 1955, Vol.87, No.20 2059 Fidelity Real Estate Corporation.2022 Fourrures Maurice Tessier Limitée.2023 Gandall Printing Co.2023 Homex Club Plan Ltd.2023 J.H.Poirier Construction Ltée.2021 J.O.Lebel Ltd.2024 Lada Company, Inc.2024 Lake Sand & Gravel Ltd.2025 La Société Historique Vaudreuil Soulanges.2025 L'Assistance Maternelle de Laprairie.2025 Le Comité du Timbre de Xoë*I de la Ville de La Tuque Inc.2020 Les Entreprises Publicitaires Inc.2020 Le Service d'Education du Collège Sacré-Cœur de Montmagny Inc.2020 Ligue des Citoyens de Naudville.2027 Louis Pineau Inc.2027 Machineries Générales Liée.2028 Nat Aronoff Oil & Coai Co.Ltd.2028 N.Levine & Son Inc.202* Plateau Construction Inc.2029 Sam Tabak Inc.2029 Service de Réhabilitation et de Recherches pour Alcooliques.2029 Silvene Industrie Ltd.2030 Solon Holdings Inc.2030 Standard Investments Incorporated.2030 Summit Inc.2031 Victorian Order of Nurses Greater Montreal Branch.2031 Victoria Rug Company Ltd.2031 Proclamation*: Concernant l'érection de la paroisse de St-Félix-d'Otis.2048 Sièges sociaux: La Compagnie du Bassin de Laprairie Ltée \u2014 The Laprairie Basin Company Ltd.2049 Les Entreprises St-Josepb Ltée.2050 Ventes, Loi de faillite: Legendre Automobile Inc.2051 P.E.Authier Co.Ltée.2050 Robidoux, Antoine.2051 Vente par licitation: Desmarchais et vir vs Desmarchais et al.2052 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi: Fortin vs Perreault.2054 Beauharnois: La Caisse Populaire de Ste-Cécile de Salaberry vs L'Industrie Linière Salaberry Limitée.2054 Iberville: La commission du Prêt Agricole Canadien vs Daoust.2054 Joliette: Fidelity Real Estate Corporation.2022 Fourrures Maurice Tessier Limitée.2023 Gandall Printing Co.2023 Homex Club Plan Ltd.2023 J.H.Poirier Construction Ltée.2024 J.O.Lebel Ltd.2024 Lada Companv, Inc.2024 Lake Sand & Gravel Ltd.2025 La Société Historique Vaudreuil Soulanges.2025 L'Assistance Maternelle de Laprairie.2025 Le Comité du Timbre de Noë I de la Ville de La Tuque Inc.2020 Les Entreprises Publicitaires Inc.2020 Le Service d'Éducation du Collège Sacré-Cœur de Montmagny Inc.2026 Ligue des Citoyens de Naudville.2027 Louis Pineau Inc.2027 Machineries Générales Ltée.2028 Nat Aronoff Oil & Coal Co.Ltd.2028 N.Levine & Son Inc.2028 Plateau Construction Inc.2029 Sam Tabak Inc.2029 Service de Réhabilitation et de Recherches pour Alcooliques.2029 Silvene Industrie Ltd.2030 Solon Holdings Inc.2030 Standard Investments Incorporated.2030 Summit Inc.2031 Victorian Order of Nurses Greater Montreal Branch.2031 Victoria Rug Company Ltd.2031 Proclamation: Concerning the erection of the parish of St-Félix-d'Otis.2048 Head Offices: La Compagnie du Bassin de Laprairie Ltée \u2014 The Laprairie Basin Company Ltd.2049 Les Entreprises St-Joseph Ltée.2050 Sales, Bankruptcy Act: Legendre Automobile Inc.2051 P.E.Authier Co.Ltée.2050 Robidoux, Antoine.2051 Sale by Licitation: Desmarchais et vir vs Desmarchais et al.2052 SHERIFFS' SALES: Abitibi: Fortin vs Perreault.2054 Beauharnois: La Caisse Populaire de Ste-Cécile de Salaberry vs L'Industrie Linière Salaberry Limitée.2054 Iberville: The Canadian Farm Loan Board vs Daoust.\".2054 Joliette: Ordre Indépendant des Forestiers vs Independent Order of Foresters vs La La Brèche.2055 Brèche.2055 2060 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2 juillet 1956, Tome 87, N° 26 Québec: Sternlieb et al vs Rouleau.2055 Rimouski : Levasseur & Frère Inc.vs Imbeault.2056 Terrebonne: Patenaude vs Martin.2056 Villeneuve vs Gariépy.2057 40189-O Quebec: Sternlieb et al vs Rouleau.*.2055 Rimouski : Levasseur & Frère Inc.vs Imbeault.2056 Terrebonne: Patenaude vs Martin.2056 Villeneuve vs Gariépy.2057 40189-o Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.