Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 31 (no 52)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1955-12-31, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 87, N* 52 4003 Vol.87, No.52 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Quebec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 31 décembre 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, December 31st, 1955 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 4004 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Si décembre 1955, Tome 87, N° 52 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Heine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Heine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 206 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est.comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: Si la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.H.\u2014 Les chiiFres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.H.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS, RÉDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.Government House.Quebec, June 27th, 1940.3S933 \u2014 1 -52 38933 \u2014 1 -52 Lettres patentes Letters Patent (P.G.13235-50) Aluminium Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec îles lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1955, constituant en corporation: Denyse Forget, Suzanne Lefebvre et Rita Angers, toutes sténographes, filles majeures, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer sous toutes ses formes, l'industrie et le commerce de constructeurs et entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Aluminium Construction Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(A.G.13235-55) Aluminium Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November 1955.incorporating: Denyse Forget, Suzanne Lefebvre and Rita Angers, all stenographers, filles majeures, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of, and deal in general builders and contractors, under the name of \"Aluminium Construction Inc.\".with a total capital stock of S40,000, divided into 200 common shares of a par value of 8100 each and 200 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General. Ql EH EC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4005 (P.G.12921-55) Anthony Yacovelli Ltd.Avis est donné qu'qn vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Anthony Yacovelli, gérant, Jeanne Beaudry Yacovelli.ménagère, épouse séparée de biens dudit Anthony Yacovelli, tous deux de la cité de Verdun et Roch Yacovelli, marchand, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ou aucune de ses spécialités tous ou aucun des commerces suivants: appareils et équipements électriques, lampes, radios, télévisions ameublement et accessoires de maison, sous le nom de \"Anthony Yacovelli Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de 810 chacune et 000 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12927-55) Baillargeon & Dion Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1955, constituant en corporation: Damase Baillargeon, Marcel Dion, tous deux maîtres-plombiers, et Hollande Dufresnc, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Marcel Dion, et dûment autorisée aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires en général dans le commerce de plombiers, poseurs d'appareils à vapeur, d'installation d'appareils de chauffage sanitaire et autre travaux connexes, sous le nom de\"Bail-largeon & Dion Incorporé\", avec un capital total de 810,000.divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1980 Des Carrières, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.13012-55) Bates RD.BIdg.Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date, du dixième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Benjamin Shulman, Frank Mel-vin Godine, avocats et Albert Edward Liddell, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter et administrer une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Bates RD.Bldg.Co.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 1,00 Oactions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Outremont, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41439 C.E.CANTIN.(A.G.12921-55) Anthony Yacovelli Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955, incorporating: Anthony Yacovelli, manager, Jeanne Beaudry Yacovelli, housewife, wife separate as to property of the said Anthony Yacovelli, both of the city of Verdun, and Hoch Yacovelli, merchant, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in all or any of its branches all or any one of the following businesses, electrical fixtures and equipment, lamps, radios, televisions, household furniture and accessories, under the name of \"Anthony Yacovelli Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided info 4.000 common shares of 810 each and into 600 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.12927-55) Baillargeon & Dion Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November 1955, incorporating: Damase Baillargeon, Marcel Dion, both master-plumbers and Rollande Dufresne, secretary, wife separate as to property of the said Marcel Dion, and duly authorized for the purposes herein, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To generally carry on the business of plumbers, installing steam apparatus, sanitary heating apparatus and other operations connected therewith, under the name of \"Baillargeon & Dion Incorporé\", with a total capital slock of 840,000.divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 19S0 des Carrières, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN.41139 Deputy Attorney General.(A.G.13012-55) Bates RD.Bldg.Co.Notice is hereby given that under Part I df the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955.incorporating: Benjamin Shuhnan, Frank Melvin Godine, advocates, and Albert Edward Liddell, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To purchase and manage a certain immoveable property, under the anme of \"BatesRD.Bldg.Co.\", with a total capital stock of S10.000, divided into 1,000 shares of S10 each.The head office of the company will be at Outremont, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General. 4006 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 (P.G.130S0-55) Birchwood Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de novembre 195\"), constituant en corporation: Samuel (\"liait, Harry L.Arono-vitdi, Abraham Sinister, avocats, et Freda Pomcrance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de ' Birch wood Holdings Inc.\", avec un capital-actions divisé en 1.000 actions ordinaires sans valeur au pair et 1.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de novembre 1955.L'Assistant-procu re ur gén é ral, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13060-55) Bouchard & Bouchard Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix novembre 1955, constituant en corporation: Armand Bouchard, industriel.Monique Morin Bouchard, épouse commune en biens dudit Armand Bouchard et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Saint-Rédempteur, et Armand Mainguy, comptable, de Québec, tous du district judiciaire de Québec pour les objets suivants: Fabrication, installation de tout objet mobilier ou immobilier en fer et placage de métal de toutes sortes, sous le nom de \"Bouchard & Bouchard Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en '100 actions communes de S50 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Rédempteur, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-o C.E.CANTIN.(P.G.12891-55) Decclles Avenue Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du troisième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Mclvin Hothman.avocat, Henry Nevard.étudiant, tous deux de Westmount et Sylvia Vineberg.secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Deeelles Avenue Holdings Ltd.\", avec un capital total de 821.000.divisé en 300 actions ordinaires de $10 chacune et 180 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce troisième jour de novembre 1955.L*Assist ant -] > roeu reu r généra 1, 41439 C.E.CANTIN.(A.G.13080-55) Birchwood Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955, incorporating: Samuel (\"liait, Harry L.Aronovitch, Abraham Sinister, advocates, and Freda Pomerance, Secretary, spinster of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Birchwood Holdings Inc.\", with a total capital stock divided into 1.000 common shares of no par value and into 1.000 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November.1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13060-55) Bouchard & Bouchard Ltcc Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November 1955, incorporating: Armand Bouchard, industrialist, Monique Morin Bouchard, wife common as to property of the said Armand Bouchard and duly authorized by him for the purposes herein, both of Saint Rédempteur, and Armand Mainguy, accountant, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and install any attachable or detachable object in iron or metal plating of every nature and kind, under the name of \"Bouchard & Bouchard Ltée\", with a total capital stock of 810,000, divided into 400 common shares of 850 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint Rédempteur, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November 1955, C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12891-55) Decclles Avenue Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of November 1955, incorporating: Mclvin Rothman, advocate, Henry Nevard, student, both of Westmount, and Sylvia Vineberg, secretary, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Deeelles Avenue Holdings Ltd.\", with a total capital stock of 821.000.divided into 300 common shares of 810 each and into ISO preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1055, Vol.87, No.52 4007 (P.G.12994-55) Dcsmarais & Lemairc Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit novembre 1955, constituant en corporation: Jean-Paul Desmarais, cultivateur, Paid Lemairc, mécanicien, tous deux de Frelighsburg, district judiciaire de Bedford, et Gabriel Houle, marchand, d'Iberville, district judiciaire d'Iber-ville, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie générale de construction, sous le nom de \"Desmarais & Lemairc Ltée\", avec un capital total de S50,000, divisé en 700 actions communes de 810 chacune et en 130 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Frelighsburg, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12896-55) Dolansky Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze novembre 1955, constituant en corporation: Charles H.Dolansky, manufacturier, Edward Samuel Berger, avocat et Sureka Wasserinan, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Dolansky Investment Corp.\", avec un capital-actions divisé en 1.000 actions catégorie \"A\" avec droit de vote et sans valeur au pair, 1,000 actions catégorie \"B\" sans droit de vote et sans valeur au pair et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41139 C.E.CANTIN.(P.G.12961-55) Doucct Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit novembre 1955, constituant en corporation: Jérôme Doucct, industriel, Thomas Gagnon, comptable, et Raymond Arsenault, commis, tous de Baie Comeau, district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de véhicules automobiles, de leurs parties et accessoires, sous le nom de \"Doucct Automobiles Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions communes de S100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baie Comeau, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-Q C.E.CANTIN.(A.G.12994-55) Dcsmarais & Lemairc Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November 1955, incorporating: Jean-Paul Dcsmarais, farmer.Paid Lemaire, mechanic, both of Frelighsburg.judicial district of Bedford, and Gabriel Houle, merchant, d'Iberville, judicial district of Iberville, for the following purposes: To carry on the operations of a general construction company, under the name of \"Dcsmarais & Lemaire Ltée\".with a total capital stock of 850.000, divided into 700 common shares of 810 each and 430 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Frelighsburg, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12896-55) Dolansky Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1955, incorporating: Charles H.Dolansky, manufacturer, Edward Samuel Berger, advocate, and Sureka Wasscrman, secretary, spinster of the full age of majority, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Dolansky Investment Q>rp.\", with a capital stock divided into 1,000 class \"A\" voting, no par value shares, 1,000 class \"B\" non-voting shares of no par value, and into 2,000 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1955.C.E.CANTIN.41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.12964-55) Doucct Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November 1955, incorporating: Jerome Doucct.industrialist, Thomas Gagnon, accountant, and Raymond Arseneault, clerk, all of Baie Comeau, judicial district of Saguenay, for the following purposes: To manufacture and deal in motor vehicle and parts and accessories thereof, under the name of \"Doucct Automobiles Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Baie Comeau, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General. 4008 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 (P.G.13025-55) Eli-on Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Bernard Diamond, J.Steve Bless, avocats, de Montréal, et Louis Orcnstein, avocat.d'Outreinont.tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Klron Realties Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1109 rue Bernard, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général.\u202211-139 C.E.CANTIN.(P.G.13022-55) Federal Frozen Foods Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour de novembre 1955, constituant en corporation: David Slopaek, boucher, de Ville Mont-Royal, Ben Slopaek, boucher, de Montréal, et Max Slapack, avocat, de Côte St-Luc, tous du district judiciaire de Montréal, pour les*objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'aliments congelés, sous le nom de \"Federal Frozen Foods Ltd.\", avec un capital total de S40,000, divisé en 100 actions ordinojres de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de novembre 1955.L'Assist a n t-proci i reur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13019-55) Flash Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf novembre 1955, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat et conseil en loi de la Reine, de West mount, Alan Bernard Gold, avocat, de Montréal et Murray Lapin, avocat, de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'électriciens, manufacturiers et poseurs d'installations électriques et fournir le service relativement à icclles, sous le nom de \"Flash Electric Inc.\", avec un capital total de S25.000, divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4363 rue Drolet, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(A.G.13025-55) I.I ion Realties Ltd.Notice is hereby given that under Fart I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955, incorporating: Bernard Diamond, J.Steve Bless, advocates, of Montreal, ami Louis Orenstein, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Elron Realties Ltd.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 100 common shares of 8100 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at.110!) Bernard street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the ollice of the Attorney General, this tenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13022-55) Federal Frozen Foods Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of November, 1955, incorporating: David Slopaek, butcher, of the town of Mount Royal, Ben Slopaek, butcher, of Montreal, and Max Slapack, advocate, of Côte St.Luc, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in frozen foods, under the name of \"Federal Frozen Foods Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 100 common shares of 8100 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head olfice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.1.3019-55) Flash Electric Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November, 1955, incorporating: Marcus Meyer Sperber, advocate and Queen's Counsel, of Wcst-mount, Alan Bernard Gold, advocate, of Montreal, and Murray Lapin, advocate, of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of electricians, manufacturers and installers of electrical construction and to provide maintenance therefor, under the name of \"Flash Electric Inc.\", with a total capital stock of 825,000, divided into 200 preferred shares of the par value of 8100 each and into 500 common shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at 4363 Drolet street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4009 (P.G.13008-55) Globe Steel Products Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de In première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de novembre 1955, constituant, en corporation: Louis M.Benjamin, Louis Freedman, avocats, Sadie Gersovitz, secrétaire, fille majeure, de Montréal, et Irwin A.Frankel.avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district, judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce général d'acier, fer, métal en feuille, bois, caoutchouc, accessoire de ferronnerie et de plomberie, porcelaine et produits de verrerie, sous le nom de \"Globe Steel Products Co.Ltd.\", avec un capital total «le 820,000, divisé en 200 actions ordinaires «le 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 414 rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour «le novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12920-55) H.J.B.Hamilton Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes en date «lu «lou/.ième jour «le novembre 1955, constituant en corporation: Samuel Grecnblatt, Cyril! E.Sebwisberg, avocats et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agents «ni représentants de manufacturiers, fabricants «le gilets, bas, foulards, chapeaux, bonnets, chaussettes, pantalons, jaquettes, coupe-vent, mouchoirs, gants, cravates, casquettes et sous-vêtements, sous le nom de \"IL J.B.Hamilton Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 10 ouest, rue Ontario, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41139 C.E.CANTIN.(P.G.13004-55) J.H.Sherrick Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes en date «lu dix novembre 1955, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, conseil en loi de la Heine, avocat, «le Westmount, Alan Bernard Gold, avocat, de Mtmtréal et Murray Lapin, avocat, de Ilampstead, tous du «listrict judiciaire «le Montréal, pour les objets suivants: Négocier et exercer le commerce «le véhicules-moteurs, camions, pièces d'automobiles, avions, moteurs d'avions, bateaux à moteur, radios, réfrigérateurs, bicyclettes, motocyclettes et accessoires, sous le nom de \"J.II.Sherrick Inc.\", avec un capital total «le S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI0 chacune.(A.G.13008-55) Globe Steel Products Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955.incorporating: Louis M.Benjamin, Louis Frecdman, advocates, Sadie Gersovitz.secretary, spinster, of Montreal, and Irwin A.Frankel, advocate, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in generally in steel, iron, sheet, metal, wood, rubber, hardware supplies, plumbing supplies, china and glass products, under the name of \"Globe Steel Products Co.Ltd.\", with a total capital stock of 820.000, divided into 200 common shares of 8100 each.The head office r the company will be at 414 St.James street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November.1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.12920-55) II.J.B.Hamilton Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1955, incorporating: Samuel Green-blatt, Cyril E.Schwisbcrg, advocates, and Anne Zifkin.secretary, spinster of the full age of majority, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers agents or representatives of manufacturers who make sweaters, hosiery, scarves, bonnets, stockings, pants, jackets, windbreakers, had kerchiefs, gloves, ties, caps and underwear, under the name of \"IL J.B.Hamilton Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of S100 each.The head office of the company will be at 10 Ontario St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1955.('.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13064-55) J.II.Sherrh'k Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955.incorporating: Marcus Meyer Sperber.Queen's Counsel, advocate, of West-mount, Alan Bernard Gold, advocate, of Montreal*, and Murray Lapin, advocate, of Hampstead, all of the judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To trade and deal in motor cars, nu^or trucks, motor parts, aircraft, aircraft motors, motor boats, radios, refrigerators, bicycles, motrocycles and accessories, under the name of \"J.H.Sherrick Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of the par value of 810 each and into 3,000 preferred shares of the par value of 810 each. 4010 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 Le siège social de la compagnie sera à 8930 The head office of the company will be al Boulevard Lajcuncsse, Montréal, district judi- 8930 Lajcunesse Boulevard, Montreal, judiciat ciaire de Montréal.district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le dix Dated at the office of the Attorney General, novembre 1955.this tenth day of November, 1955.L'Assistant-procureur général, C.E.CANTIN, 41439 C.E.CANTIN.41439-o Deputy Attorney General.(P.G.12924-55) Junior Jcnls Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinquième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, Irwin S.Brodie, avocats, Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure et Theodore II.Polisuk.étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général d'articles fabriqués de textiles, sous le nom de \"Junior Jents Inc.\", avec un capital total de 810,000.divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2019 rue Moreau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13001-55) Lachenaic Associates Inc.(A.G.12924-55) Junior Jents Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of November, 1955, incorporating: Samuel Greenblatt, Irwin S.Brodie, advocates, Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, and Theodore II.Polisuk, student-at-law, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in articles manufactured from textiles, under the name of \"Junior Jents Inc.\".with a total capital stock of 8-10,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at \u20222019 Moreau St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13001-55) Lachcnaie Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov-provinec de Québec, des lettres patentes en date inec of Quebec, bearing date the ninth day of du neuvième jour de novembre 1955.constituant November, 1955, incorporating: Max S.Kauf-en corporation: Max S.Kaufman, avocat, Harriet man, advocate, Harriet Bcutel, bookkeeper, both Beutel, teneusc de livres, tous deux de West- of West mount, and Joseph R.Hoffman, advocate, mount, et Joseph R.Hoffman, avocat, de Mont- of Montreal, all of the judicial district of Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, real, for the following purposes: pour les objets suivants: Acquérir par achat, louer, échanger ou autre- To acquire by purchase, lease, exchange or- ment, des terrains et tous biens ou intérêt en otherwise land and any estate or interest therein, iccux, sous le nom de \"Lachcnaie Associates under the name of \"Lachenaic Associates Inc.\", Inc.\", avec un capital total de 810,000, divise with a total capital stock of 810,000, divided en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.into 100 common shares of 8100 each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General, neuvième jour de novembre 1955.this ninth day of November, 1955.L'Assistant-procureur général, C.E.CANTIN 41439 C.E.CANTIN.41439-o Deputy Attorney General.(P.G.12869-55) (A.G.12869-55) Laroche Distribution Inc.Laroche Distribution Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- provinec de Québec des lettres patentes, en date ince of Quebec, bearing date the seventh day du sept novembre 1955, constituant en corpo- of November 1955, incorporating: François ration: François-Robert Laroche; homme d'af- Robert Laroche, business man, Albert LaRoche, faircs, Albert LaRoche, ingénieur professionnel, professional engineer, both of Saint Lambert] tous deux de Saint-Lambert, et Luc Bérard, and Luc Bérard, bank manager, of Montreal, gérant de banque, de Montréal, tous du district all of the judicial district of Montreal, for the judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: following purposes: Manufacturer et exercer le commerce de pro- To manufacture and deal in wholesale pharma- duits pharmaceutiques en gros, d'articles de ceutical products, toilet requisites and articles toilette et articles d'usage domestique ou person- of a domestic or personal nature, under the nel, sous le nom de \"Laroche Distribution Inc.\".name of \"Laroche Distribution Inc.\", with a avec un capital total de 875,000, divisé en 5,000 total capital stock of 875,000, divided into 5,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.December 31st, 1955, Tome 87, No.52 4011 actions ordinaires de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12791-55) Laiiriii Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf octobre 1955.constituant en corporation: Louis Bowen Laurin, industriel, Anna Eleanor Price Laurin, ménagère, épouse séparée de biens de Louis Bowen Laurin et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Wilfrid Lawson, comptable, tons trois de Ste-Dorotliée, Winnifred Gertrude Bowen Laurin.veuve d'A-ristc Elisée Laurin.en son vivant médecin et Martha Gertrude Laurin.institutrice, fille majeure, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou des intérêts en iceux; ériger des bâtisses et exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Laurin Enterprises Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Dorothée, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf octobre 1955.L'Assistant-procureur général, 11439 C.E.CANTIN.(P.G.12886-55) Lemieux Télévision Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze novembre 1955, constituant en corporation: Georges Villeneuve, garagiste, de Pointeau-Pic.district judiciaire de Saguenay.Claude Lemieux.agent-vendeur, et lîaymonde Villeneuve Lemieux.ménagère, épouse contract uelle-nicnt séparée de biens de Claude Lemieux, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ces deux derniers de Kénogami, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles, effets mobiliers, matériaux pour la construction et appareils de télévision et de radio, sous le nom de \"Lemieux Télévision Limitée\", avec un capital total de $40.000.divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 82, rue Stc-Famillc, Kénogami.district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.13033-55) Master Enterprises Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date common shares of $10 each and 250 preferred shares of 8100 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12791-55) Laurin Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of October, 1955, incorporating: Louis Bowen Laurin, Industrialist.Anna Eleanor Price Laurin, housewife, wife separate as to property of Louis Bowen Laurin, and duly authorized by him for the purpose of these presents, Wilfrid Lawson, accountant, all three of Ste.Dorothée.Winnifred Gertrude Bowen Laurin, widow of Ariste Elisée Laurin.in his lifetime medical doctor, and Martha Gertrude Laurin, school teacher, spinster of the fid I age of majority, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire lands or interests therein; to erect buildings and to deal in building materials, under the name of \"Laurin Enterprises Inc.\", with a total capital stock of 850.000, divided into 250 shares of 8100 each and into 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Ste.Dorothée, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of October, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.128S6-55) Lemieux Télévision Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November 1955, incorporating: Georges Villeneuve, garage-keeper, of Pointe-au-Pic, judicial district of Saguenay.Claude Lemieux, sales agent, and lîaymonde Villeneuve Lemieux, housewife, wife contractually separate as to property of Claude Lemieux, and duly authorized by him for the purposes herein, the two latter of Kenogami, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in furniture, household furnishings, building materials and television and radio sets, under the name of \"Lemieux Télévision Limitée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at 82 St.Famille street, Kenogami, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.13033-55) Master Enterprises Co.Ltd.Notice Is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of 4012 GAZETTE OFFIl 'IELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, K° 52 du dix novembre 1955, constituant en corporation: Albert Malouf.Peter Shortcno, avocats cl Lily Malouf, secrétaire, fille majeure, tous de Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Négocier des immeubles et transiger les affaires d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Master Enterprises Co.Ltd.\".avec un capital total de $40.000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et 200 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 211 rue Dante, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13062-55) M.Busch Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1955.constituant en corporation: Jean-Paul Dansereau, avocat, Micheline Désormiers, secrétaire et Roland R.Beaudry, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, sous le nom de \"M.Busch Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.\u2022 L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12968-55) Montreal Frame & Furniture Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des .compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit novembre 1955, constituant en corporation: Jack Goodlin, John Turchyniak, manufacturiers, Marcel Deniers, comptable et Léon Goodlin, vendeur, tous des cité et «listrict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchand général de meubles et garnitures de maison, sous le nom de \"Montreal Frame & Furniture Co.Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41439 C.E.CANTIN.(P.G.13063-55) Nevitt's Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix novembre 1955, constituant en corporation: Milton L.Klein, Arthur I.Bronstein, avocats et Mildred Brown, secrétaire, fille ma- November, 1955, incorporating: Albert.Malouf' Peter Shortenor.advocates, and Lily Malouf.secretary, spinster, all of the town of Mount Royal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate and to carry on the business of general contractors, under the naine of \"Master Enterprises Co.Ltd.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 200.common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 211 Dante street, Montreal, judicial district of Mont real.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November, 1955.C.F.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13062-55) M.Busch Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1955, incorporating: Jean-Paid Dansereau.lawyer, Micheline Désormiers, secretary and Roland-R.Beaudi , chartered accountant, all of the city and ju \"ial «listrict «>f Montréal, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, under the name of \"M.Busch Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 400 shares «>f $100 each.The hea«l office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date«l at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.12968-55) Montreal Frame & Furniture Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1955, incorporating: Jack Goodlin, John Turchyniak, manufacturers.Marcel Deniers, accountant, and Léon Goodlin, salesman, all of the city and judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dealers generally in furniture and house furnishings, under the name of \"Montreal Frame & Furniture Co.Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 250 common shares of a par value of $100 each and into 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head offic«' of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dateil at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13063-55) Nevitt's Inc.< Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955, incorporating: Milton L.Klein, Arthur I.Bronstein, advocates, and Mildred Brown, secretary, spinster, all of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Tome 87, No.52 4013 jeurc, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de chaussures et souliers, habits et vêtements, sous le nom de \"Nevitt's Inc.\", avec un capital total «le 840,000, divisé en2.000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 11439 C.E.CANTIN.(P.G.13011-55) New Castle Mining Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1955, constituant en corporation: Robert Lafleur.C.R., avocat, Marcelle Flamand, secrétaire, fille majeure, tous deux d'Ontremont et .lean-Paul Sle-Marie.avocat.de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"New Cast le Mining Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de 81,000,000, divisé en 4.000,000 d'actions d'une valeur au pair de 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 11439 C.E.CANTIN.(P.G.13176-55) Newkirk & Co.Ltd.(Quebec) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de novembre 1955, constituant en corporation: .1.Jacques Beau-chemin.Paul Ranger, tous deux avocats, d'Ou-tremont, et Claude Beauchemin, avocat, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Diriger un commerce général «l'immeuble et «le courtage, sous le nom de \"Newkirk & Co.Ltd.(Quebec)\", avec un capital total de 8500,-000, divisé en 5,000 actions de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, ce vingt-deuxième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur g«'*néral, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13040-55) N.Rubin Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in fottwear and shoes, clothing and clothing apparel, under the name of \"Nevitt's Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November.1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13044-55) New Castle Mining Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieute-tenaut-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1955, incorporating: Robert Lafleur, Q.C., advocate, Marcelle Flamand, secretary, spinster, both of Outremont, ami Jean-Paul Ste-Marie.advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"New Castle Mining Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 81.000,-000, divided into 4,000,000 shares of a par value of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount «)f the price pai«l or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November.1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.13176-55) Newkirk & Co.Ltd.(Quebec) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1955, incorporating: J.Jac«pies Beauchemin, Paul Ranger, both Attorneys, of Outremont, and Claude Beauchemin, attorney, of Westmount.all of the judicial district of Montreal, for the following purp«>scs: To conduct a general real estate brokerage and agency business, under the name of \"Newkirk & Co.Ltd.(Quebec)\", with a total capital stock of 8500.000, divided into 5,000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13040-55) N.Rubin Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth 4014 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome S7, N° 52 du huitième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Max Slapack, avocat, de Côte St-Luc, Gregory Charlap, avocat et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tissus et produits de tissus, sous le nom de \"N.Rubin Ltd.\", avec un capital total de S 100,000, divisé en 200 actions ordinaires de §100 chacune et S.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41439 C.E.CANTIN.(P.G.13040-55) Orchidée Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1955.constituant en corporation: Bernardin Blanchet, Bertrand Marcotte, et Paul Bélanger, avocats, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme fleuriste, sous le nom de \"Orchidée Inc.\", avec un capital total de §10,000, divisé en 100 actions de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12748-55) Park Ventures Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuvième jour d'octobre 1955, constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de West mount, Sydney Phillips, avocat, Rose-Marie Bourgoing et Tessy Frankel, sténographes, filles majeures, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire, ériger, acheter, louer ou autrement acquérir et posséder, aménager, exploiter et entretenir des motels, hôtels, restaurants, cafétéria et salles de rafrichissement, garages et postes de stationnement extérieurs pour automobiles, sous le nom de \"Park Ventures Ltd.\", avec un capital total de 839.900, divisé en 199 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-neuvième jour d'octobre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12895-55) Patty Page Incorporée Patty Page Incorporated day of November, 1955, incorporating: Max Slapack, advocate, of Côte St.Luc, Gregory Charlap, advocate, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in fabrics and fabric products, under the name of \"N.Rubin Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 8,000 preferred shares of $10 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this eighth day of November, 1955.C.K.CANTIN, 41349-0 Deputy Attorney General.(A.G.13040-55) Orchidée Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November 1955, incorporating: Bernardin Blanchet, Bertrand Marcotte and Paul Bélanger, advocates, of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as florist, under the name of \"Orchidée Inc.\", with a total capital stock of .«10,000, divided into 100 shares of S10|) each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.I271S-55) Park Ventures Lid.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of October, 1955, incorporating: John J.Wasserman, advocate, of Westmount, Sydney Phillips, advocate, Rose-Marie Bourgoing and Tessy Frankel, stenographers, spinsters of the full age of majority, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To construct, build, purchase, lease or otherwise acquire and own, equip, operate* and maintain, motels, hotels, restaurants, cafes and re-frésinent rooms, garages and outdoor automobile parking stations, under the name of \"Park Ventures Ltd.\", with a total capital stock of S39.900, divided into 199 common shares of the par value of §100 each and into 200 preferred shares of the par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of October, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.12895-55) Patty Page Incorporée Patty Page Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant.-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.62 \u2022 4015 province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept novembre 1955, constituant en corporation: Bernard Xantel, avocat, de West-mount, André Surprenant, avocat et Fernande Thouin, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, toits du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de bonneterie, lingerie, gants, articles vestimentaires, vêtements de sport, articles en cuir, parapluies, ornements et nécessaires de toilette, sous le nom de \"Patty Page Incorporée \u2014 Patty Page Incorporated\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12711-55) Protestant Benevolent Association of Ile Perrot Association Bienfaisante Protestante d'Ile Perrot Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi de la compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatrième jour de novembre 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Fleurette Dugal, Bemice Cornett, S.Jean Osborne, Lilian Létourncau, ménagères de Terrasse Vaudreuil, Muriel Yet man, Gwendolyn Valade.Elizabeth D'Ambrossio, Ada Pollock, Serena Bctts, Marie Adam, Olive Batten, ménagères et Ethel Barnes, ménagère, fille majeure, d'Ile Perrot N.RR.1 tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Pourvoir et assister charitablement les pauvres et les personnes nécessiteuses, sous le nom de \"Protestant Benevolent Association of Ile Perrot \u2014 Association Bienfaisante Protestante d'Ile Perrot\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est S 10,000.Le siège social de la compagnie sera à Ile Perrot, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatrième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12993-55) Quality Packers Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept novembre 1955, constituant en corporation: Ernest Herskovitz, marchand-boucher, Erwin Ebner, marchand-boucher.Max Coblcntz, avocat, tous trois de Montréal et Gladys Watson, secrétaire, veuve de feu Everett Watson, en son vivant fabricant de matrices, de Verdun tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme importateurs, exportateurs et marchands de produits des animaux et produits laitiers, agricoles et maraîchers de toutes sortes, sous le nom de \"Quality Packers Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of November, 1955, incorporating: Bernard Nantcl, lawyer, of Westmount, André Suprenant, lawyer, and Fernande Thouin, secretary, spintcr, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes.To manufacture and deal in hosiery, lingerie, gloves, clothing, sport wear, leather goods, umbrellas, ornaments, toilet requisites, under the name of \"Patty Page Incorporée \u2014 Patty Page Incorporated\", with a capital stock divided into 1,000 shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.12711-55) Protestant Benevolent Association of He Perrot Association Bienfaisante Prolestante d'Ile Perrot Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Compagnies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of November, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Fleurette Dugal, Bernice Cornett.S.Jean Osborne, Lilian Létourneau, housewives, of Terrasse Vaudreuil.Muriel Yetman, Gwendolyn Valade, Elizabeth D'Ambrossio, Ada Pollack, Serena Betts, Marie Adam, Olive Batten, housewives, and Ethel Barnes, house-keeper, spinster, of He Perrot N.R.R.I., all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To supply and render services of a charitable nature to poor and needy persons, under the name of \"Protestant Benevolent Association of He Perrot \u2014 Association Bienfaisante Protestant d'He Perrot\".The amount to which the value of the immoveable property which the Corporation may hold, is to be limited to S10.000.The head office of the corporation will be at He Perrot, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.12993-55) Quality Packers Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of November, 1955.incorporating: Ernest Herskovitz, merchant butcher, Erwin Ebner, merchant butcher, Max Goblentz, advocate, all three of Montreal, and Gladys Watson, secretary, widow of the late Everett W'atson, in his lifetime diemaker, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of importers, exporters and dealers in animal products and dairy, farm and garden produce of all kinds, under the name of \"Quality Packers Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4016 \" GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, SI décembre 1955, Tome 87, N° 62 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13171-55) Quebec St.Lawrence Steel Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi de la compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour de novembre 1955, constituant en corporation: John Bumbray, C.R., Lovel C.Carroll, C.R., avocats, tous deux de ville Mont-Royal, Jean-Paul Cardinal, C.R., avocat, Marcel Lajeunesse.avocat, tous deux de Montréal, et Denise Jalbert, secrétaire, fille majeure de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer Je commerce qui consiste à manufacturer, produire, préparer, fondre, rafliner, acheter, vendre, négocier, faire le commerce et installer toutes sortes de métaux, y compris le travail qui consiste à traiter le cuivre dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Quebec St.Lawrence Steel Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13225-55) Raymond Perrault Auto Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1955, constituant en corporation: John Anthony Nolan, avocat, de ville St -Laurent, Howard Spear Simpson et Claude Wagner, avocats, de Montréal, tous du district judiciaire de Moid réal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de véhicules-moteurs, leurs pièces et accessoires et articles semblables; garder, exploiter et gérer des garages, sous le nom de \"Raymond Perrault Auto Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 3.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 100 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13076-55) Rome-Venice Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1955, constituant en corporation: Sol Sidney Pels, Bernard Gardner, Jules Leavitt et David L.Cahana, avocats, tous des 1,000 common shares of S10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.13171-55) Quebec St.Lawrence Steel Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1955, incorporating: John Bumbray, Q.C., Lovel C.Carroll, Q.C., advocates, both of the town of Mount Royal.Jean-Paul Cardinal, Q.C.advocate, Marcel Lajeunesse, advocate, both of Montreal, and Denise Jalbert, secretary, spinster of the full age of majority, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing, producing, preparing, smelting, refining, buying, selling, trading and dealing in and installing all kinds of metals, including the work of brass finishing in all its branches, under the name of \"Quebec St.Lawrence Steel Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of a par value of $1 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office at the Attorney General, this twenty-second day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13225-55) Raymond Perrault Auto Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date twenty-fourth day of November, 1955, incorporating: John Anthony Nolan, advocate, of ville St.Laurent, Howard Spear Simpson and Claude Wagner, advocates, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in motor vehicles, their parts and accessories, and kindred articles; to keep, operate and manage garages, under the name of \"Raymond Perrault Auto Ltd.\", with a capital stock divided into 3,000 preferred shares of the par value of S10 each and into 100 shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.13076-55) Rome-Venice Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1955, incorporating: Sol Sidney Pels, Bernard Gardner, Jules Leavitt and David L.Cahana, advocates, all of the city and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4017 cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et exploiter une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Rome-Venice Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 100 actions d'une valeur au pair de 8100 chacune.l.e siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 11439 C.E.CANTIN.(P.C.13054-55) Smelter Power Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du onze novembre 1955, constituant en corporation: Valmore A.de Billy, Jacques «le Billy, tous deux conseils en loi «le la Heine, avocats, de LVris, André Gagnon, Chimie Gagnon, avocats, «le Québec et Cilles de Billy, avocat, de Sillcry, tous du «listrict judiciaire «le Québec, pour les objets suivants: Produire, manufacturer, fournir, vendre et disposer «l'électricité et de courant électrique pour la chaleur, la lumière et l'énergie et pour toutes autres fins pour lesquelles il peut être utilisé, sous le nom «le \"Smelter Power Corporation\", avec un capital total «leS 1.200.000, divisé en 200,000 actions ordinaires de SI chacune et 200,000 actions privilégiées de S5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12906-55) South Shore Sporting Centre Inc.Centre Sportif Rive Sud Incorporé Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1955, constituant en corporation: Louis Brucbési, représentant de ventes, de Montréal, Joseph Versailles, agent d'assurances, «le Westmount, Roy Savard, agent, de Notre-Dame-de-Sacré-Cœur «le la Prairie, Roy Barrette, vendeur, de Verdun, tous du district judiciaire «le Montréal, Joseph* Jean Deniers, agent d'immeubles, de St-Michel «le Bellechasse, district judiciaire «le Montmagny et Harolde Savoy, administrateur, d'Iberville, district judiciaire d'Iberville.pour les objets suivants: Construire, entretenir et administrer des arènes et une ou «les bâtisses aménagées comme jardin d'été ou «l'hiver, sous le nom de \"South Shore Sporting Centre Inc.\u2014 Centre Sportif Rive Sud Incorporé\", avec un capital total de $750,000, divisé en 60,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le S10 chacune et 15,000 actions privilt»giées «l'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.judicial district of Montreal, for the following purposes: -< To acquire and exploit a certain immoveable property, under the name of \"Rome-Venice Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.13054-55) Smelter Power Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November, 1955, incorporating: Valmore-A.de Billy, Jacques de Billy, both Queen's Counsel, advocates of Levis, André Gagnon, Claude Gagnon, a«lvocates, of Quebec, and Gilles «le Billy, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To produce, manufacture, supply, sell and dispose of electricity and electric current for heat, light ami power and for any other purposes for which the same may be used, under the name of \"Smelter Power Corporation\", with a total capital stock of SI.200.000, divided into 200,000 common shares of SI each and into 200,000 preferred shares of S5 each.The hca«l office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of t! n.Attorney General, this eleventh dav of Novemoer, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.12966-55) South Shore Sporting Centre Inc.Centre Sportif Rive Sud Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date sixteenth day of November.1955, incorporating: Louis Bruchési, sales representative, of Montreal, Joseph Versailles, Insurance agent, of West-mount.Roy Savard, agent, of Notre-Dame-de-Sacré-C«cur «le la Prairie, Roy Barrette, salesman, of Verdun, all of the judicial district of Montreal.Joseph Jean Deniers, realtor, of St.Michel de Bellechasse, judicial district of Montmagny, ami Harolde Savoy, executive, of Iberville, judicial district of Iberville, for the following purposes: To construct, maintain and manage arenas ami summer and winter garden building or buildings, under the name of \"South Shore Sporting Centre Inc.\u2014 Centre Sportif Rive Su«l Incorporé\", with a total capital stock of $750,000, divided into 60,000 common shares of the par value of 810 each and into 15,000 preferred shares of the par value of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.* 4018 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1955, Tome 87, N° 52 (P.G.13009-55) Villeray Roof & Metal Work Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Milton Pridbain.entrepreneur, Roger Tremblay, ferblantier, et Edouard Laurin, charpentier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les commerces de plombiers, manufacturiers, entrepreneurs, couvreurs, ferblantiers, électriciens et poseurs d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de \"Villeray Roof & Metal Work Limited\", avec un capital total de 810,000, divisé en 400 actions de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, ce dixième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.13089-55) White Paints Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-septième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Georges A.Pouliot, Luc Mercure, avocat, tous deux de ville Mont-Royal et Gabrielle Lahaie, secrétaire, fdlc majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général de peintures et tous articles et composés de même nature, sous le nom de \"White Paints Co.Ltd.\" avec un capital-actions divisé en 400 sans valeur nominale au pair et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3848 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureu r gênéral, 41439 C.E.CANTIN.(P.G.12843-55) Wolac Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze novembre 1955, constituant en corporation: Oswald Lacombe, manufacturier de bois, de St-Eustache, district judiciaire de Terrebonne, Max S.Kaufman et Joseph Roy Hoffman, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de produits du bois, bois de construction et bois, sous le nom de \"Wolac Industries Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Eustache.district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 C.E.CANTIN.(A.G.13009-55) Villeray Roof & Metal Work Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955, incorporating: Milton Prid-ham, contractor, Roger Tremblay, tinsmith, and Edouard Laurin, carpenter, all of the city and judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To carry on business of plumbers, manufacturers, contractors, roofers, tinsmiths, electricians and installers of electrical appliances and supplies, under the name of \"Villeray Roof & Metal Work Limited\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 shares of S100 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this tenth dav of November.1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney General.(A.G.13089-55) While Paints Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of November, 1955, incorporating: Georges A.Pouliot, Luc Mercure, advocate, both of the town of Mount Royal, and Gabrielle Lahaie.secretary, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in paints and all kinrcd of articles and compounds, under the name of \"White Paints Co.Ltd.\", with a capital stock divided into 400 shares having no nominal or par value and into 2,000 preferred shares of SU) each.The head office of the company will be at 3848 St.James St.West, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Date«l at the office of the Attorney General, this seventeenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-0 Deputy Attorney General.(A.G.12843-55) Wolac Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November, 1955.incorporating: Oswald Lacombe, wood manufacturer of St.Eustache, judicial district of Terrebonne, Max S.Kaufman ami Joseph Roy Hoffman, advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wood products, lumber and wood, under the name of \"Wolac Industries Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of 8100 each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at St.Eustache, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439-o Deputy Attorney G encrai. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4019 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent (P.G.11982-55) Aylmer Homes Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze novembre 1955, à la compagnie \"Aylmer Homes Limited\", étendant ses pouvoirs de la manière prévue dans sa résolution du 20 octobre 1955 adoptée à cette fin.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12870-55) B.K.lobI Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze novembre 1955, à la compagnie \"B.K.Jobl Inc.\" a.) augmentant son capital de 820,000 à $250,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 8100 chacune; b) étendant ses pouvoirs et modifiant les dispositions de ses lettres patentes de la manière prévue dans son règlement numéro 10 adopté à telles fins.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12816-55) Canada Broom Supply Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du seize novembre 1955, à la compagnie \"Canada Broom Supply Co.Ltd.\", 1° refondant ses 10,000 actions privilégiées originaires de S5 chacune en 500 actions privilégiées de 8100 chacune; 2° modifiant les dispositions de ses lettres patentes, à savoir: les conditions et restrictions se rapportant aux actions privilégiées; 3° augmentant le capital-actions de 8100,000 à 8350,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,500 actions privilégiées de S100.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439 ' C.E.CANTIN.(P.G.13133-55) Canadian Simplex Sales Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze novembre 1955.à la compagnie \"Canadian Simplex Sales Company\", abrogeant une disposition de ses lettres patentes supplémentaires du 8 mai 1952, de la manière indiquée dans son règlement numéro 25 adopté à cette fin.(A.G.11982-55) Aylmer Homes Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fourteenth day of November 1955, to the company \"Aylmer Homes Limited\", extending its powers in the manner prolived therefor in a resolution dated October 20, 1955, adopted for said purpose.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12876-55) B.K.Johl Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by ghe Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twelfth day of November 1955, to the company \"B.K.Johl Inc.\", a) increasing its capital from the sum of 820,000 to 8250,000: the additional share capital being divided into 300 common shares of 8100 each and 2,000 preferred shares \u2022of S100 each; b) extending its powers and modifying the provisions of its letters patent in the manner provided therefor in By-law number 16 adopted for said purposes.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12816-55) Canada Broom Supply Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the sixteenth day of November 1955, to the company \"Canada Broom Supply Co.Ltd.\", 1.converting its 10.000 original preference shares of 85 each into 500 preference shares of 8100 each; 2.modifying the provisions of its letters patent, to wit: conditions and restrictions attaching to preference shares; 3.increasing the share capital of 8100,000 to the sum of 8350,000: the additional share capital being divided into 2,500 preferred shares of SI00.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.13133-55) Canadian Simplex Sales Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, date the fifteenth day of November 1955, to the company \"Canadian Simplex Sales Company\", repealing a provision of its supplementary letters patent of May 8, 1952, in the manner indicated in its By-law number 25 adopted for said purpose. \u20221020 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1955.Tome 87, N° 52 Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12976-55) Chantcclcrc (Limitée) Avis csl donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix novembre 1955, à la compagnie \"Chantcclerc ( Limitée)\", augmentant son capital de 820.000 à $60,000: le cailal-aetions additionnel étant divisé en 1.000 actions privilégiées de 810 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41439-0 C.K.CANTIN.(P.G.10580-55) Chic Juniors Sportswear Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept novembre 1955, à la compagnie \"Chic Juniors Sportswear Incorporated\", a) réduisant son capital de 810,000 à 89.000: le capital-actions annulé étant divisé en 10 actions de 8100 chacune; b) augmentant son capital ainsi réduit de 89.000 à 810.000: le capital-actions additionnel étant divisé en 310 actions privilégiées de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12879-55) Electro-Blender Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du du vingt-six octobre 1955, à la compagnie \"Electro-Blender Co.Ltd.\", a) convertissant ses 500 actions ordinaires de 8100 chacune en 500 actions classe \"A\" de 8100 chacune cl convertissant ses 1500 actions privilégiées de 8100 chacune en 500 actions classe \"B\" de 8100 chacune et en 1000 actions privilégiées de 8100 chacune; /;) modifiant les pouvoirs de la compagnie de la manière prévue dans son règlement numéro 46 adopté à telles fins.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1955.L'Assistant-procureur génér al.41439-o C.E.CANTIN.(P.G.10447-55) Delia Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix novembre 1955, à la compagnie \"Helia Realty Corporation\", augmentant son capital de 85,000 à 845,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 40,000 actions ordinaires de 81 chacune.Dated at the office of the Attorney General, this November fifteenth day 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12976-55) Chanteclerc (Limitée) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of November 1955.to the company \"Chantcclcrc (Limitée)\", increasing its capital from the sum of 820.000 to 800.000: the additional share capital being divided into 4.000 preferred shares of $10 each.Dated at the oflice of the Attorney General, this tenth dav of November 1955.C.E.CANTIN.41439 Deputy Attorney General.(A.G.I05S0-55) Chic Juniors Sportswear Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters paient have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the seventeenth day of November 1955.to the company \"Chic Juniors Sportswear Incorporated\", a) decreasing its capital in the amount of 810.000 to 89.000: the cancelled share capital being divided into 10 shares of 8100 each; b) increasing its capital thus dedreased form the sum of $9.000 to 810,000: the additional share capital being divided into 310 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 11439 Ceputy Attorney (\"encrai.(A.G.I2S79-55) Electro-Blender Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-six! h day of October 1955.to the company \"Electro-Blender Co.Ltd.\", a) converting its 500 common shares of $100 each into 500 class \"A\" of $100 each, ami converting its 1500 preferred shares of $100 each into 500 class \"B\" shares of $100 each and 1000 preferred shares of 8100 each; b) modifying the powers of the company in the manner provided therefor in By-law number 10 adopted for said purposes.Dated at the office of the Attorney -GeneraI.this twenty-sixth dav of October 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.10417-55) Ilelia Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of November 1955.to the company \"Ilelia Realty Corporation\", increasing its capital from the sum of $5.000 to $45.000: the additional share capital being divided into 40,000 common shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.62 4021 Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12204-55) Liberty Watch Case Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze novembre 1955, à la compagnie \"Liberty Watch Case Company Limited\", étendant ses pouvoirs de la manière prévue dans son règlement numéro 41 adopté à cette fin.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1955.L'Assistant -procureur généra 1, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.12979-55) Rôtisserie Laforte Bar-B-Q Inc.Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux novembre 1955, à la compagnie \"Rôtisserie Ti-Coq Barbecue, Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 23 juillet 1953, changeant son nom en celui de \"Rôtisserie Laforte Bar-B-Q Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.13130-55) Trans-Canada Corporation Fund Corporation de Valeurs Trans-Canada Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze novembre 1955, à la compagnie \"Trans-Canada Corporation Fund \u2014 Corporation de Valeurs Trans-Canada\", modifiant les privilèges et restrictions attachés à ses actions privilégiées de la manière prévue dans son règlement numéro 25 adopté à cette fin.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-o C.E.CANTIN.(P.G.12938-55) Variety Textile Manufacturers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze novembre 1955, à la compagnie \"Varietv Textile Manufacturers Ltd.\" augmentant son capital de 820,000 à 8120,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 10,000 actions privilégiées de S10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12264-55) Liberty Watch Case Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twelfth day of November 1955, to the company \"Liberty Watch Case Company Limited\", extending its powers in the manner provided therefor in its By-law number 41 adopted for said purposes: Dated at the oflice of the Attorney General, this twelfth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12979-55) Rôtisserie Laforte Bar-B-Q Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the second day of November 1955, to the company \"Rôtisserie Ti-Coq Barbecue, Inc.\", constituted as a corporation under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated July 23.1953.changing its name to that of \"Rôtisserie Laforte Bar-B-Q Inc.\".Dated at the oflice of the Attorney General, this second day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.13130-55) .Trans-Canada Corporation Fund Corporation de Valeurs Trans-Canada Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eleventh day of November 1955, to the company \"Trans-Canada Corporation Fund \u2014 Corporation de Valeurs Trans-Canada\", modifying the privileges and restrictions attaching to the company's preference shares in the manner provided therefor in its By-law 25 adopted for said purpose.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12938-55) Variety Textile Manufacturers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eleventh day of November 1955, to the company \"Variety Textile Manufacturers Ltd.\", increasing its capital from the sum of S20.000 to SI20,000: the additional share capital being divided into 10,000 preferred shares of S10 each.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of November 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General. 4022 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, December 81st, 1955, Vol.87, No.62 Arrêtés en Conseils Orders in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL ORDER IN COUNCIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 1207 Number 1267 Québec, le 15 décembre 1955.Quebec, December 15, 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Section \"B\" Part \"B\" Concernant des modifications au décret relatif Concehnino amendments of the decree relating à l'industrie de la construction dans la région to the construction industry in the region of dc Sorel.Sorcl.Attendu que, conformément aux dispositions whereas, pursuant to the provisions of the de la Loi de la convention collective (Statuts Collective Agreement Act (Revised Statutes of refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amen- Québec 1911, chapter 163 and amendments) dements), les parties contractantes à la conven- the contracting parlies to the collective labour tion collective de travail relative à l'industrie agreement relating to the construction industry de la construction dans la région «le Sorel, rendue in the region of Sorel.rendered obligatory by the obligatoire par le décret numéro 002 du 9 juin decree number 002 of June 9, 1954, amended 1954, amendé par les arrêtés en conseil numéros by Orders in Council numbers 20-F, 970-C and 26-F, 970-C et 906 des 5 janvier, 7 et 11 sep- 900 of January 5.September 7 and 14 1955, tembre 1955, ont présenté au Ministre du Travail have petitioned the Minister of Labour to submit, des requêtes si Pellet dc soumettre à l'apprécia- to the consideration and decision of the Licutc-tion et à la décision du Lieutenant-Gouverneur mint-Governor in Council some amendments en Conseil certaines modifications audit décret; to the said decree; Attendu que lesdites requêtes ont été pu- Whereas the petitions have been published bliées dans la Gazette officielle (le Québec, édition in the Quebec official Gazette, issues of October des 22 octobre, 5 et 12 novembre 1955; 22, November 5 and 12, 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée whereas no objection has been made against contre l'approbation des modifications proposées; the approval of the proposed amendments; Il est ordonne, en conséquence, sur la It is ordered, therefore, upon the recommend-proposition de l'honorable Ministre du Travail: ation of the Honourable the Minister of Labour: Que ledit décret, numéro 002, soit modifié That the said decree, number 602, be amended comme suit: as follows: 1° La liste des parties contractantes de 1.The list of contracting parties of the first première part est modifiée comme suit: pari is amended as follows: a) En ajoutant les noms des entrepreneurs a) By adding the names of tue following suivants: contractors: \"Bruncau & Chassé, Lucien Péloquin, Origène \"Briineau & Chassé, Lucien Péloquin, Origène Labonté, Roger Péloquin, Jean-Paul Jacques, Labonté, Roger Péloquin, Jean-Paul Jacques, Construction Économique Enr.(Gérard Joly), Construction Économique Enr.(Gérard Joly), Albéric Héroux, Marcel Cotnoir, Denis Duchar- Albéric Héroux.Marcel Cotnoir, Denis Duehar-me, Les Foyers Unis\".me.Les Foyers Unis\".b) En remplaçant le nom de \"Elzéar Cour- /;) By replacing the name of \"Elzéar Cour-noyer\" par \"Tracy Construction Inc.(L.Cour- noyer\" by \"Tracy (\"oustruction Inc.(L.Cour-noyer)\".noyer)\".c) En radiant le nom de \"René Challancin\".c) By deleting the name of \"René Challancin\".2° Le dernier alinéa du paragraphe \"b\" de 2.The last paragraph of subsection \"6\" of l'article II est remplacé par le suivant: section II is replaced by the following: \"Nonobstant les dispositions précédentes, dans \"Notwithstanding the foregoing provisions, le cas de travaux de construction exécutés employees engaged in construction operations dans la zone II et dont le coût, salaires et maté- carried out in zone II and amounting to §25,-riaux compris, s'élève à §25,000.00 ou plus, les 000.00 or more, including wages and materials, taux minima fixés pour la zone I sont payables shall be paid the minimum rates established for aux salariés qui exécutent tels travaux.\" zone L\" Z° L'échelle de salaire apparaissant au para- 3.The wage scale appearing in subsection \"a\" graphe \"a\" de l'article III, est remplacé par la of section III, is replaced by the following: suivante: Salaires horaires Hourly rates Zones Métiers \u2014 Trades: I II Briqueteur, plâtrier, maçon et finisseur de ciment \u2014 Bricklayer, plasterer, mason and cement finisher.S 1.70 S 1.00 Tailleur de granit et dc pierre \u2014 Stone and granite cutter.1.70 1.60 Charpentier-menuisier \u2014 Carpent er-joiner.1.50 1.40 Cliarpentier-mcnuisier et, peintre travaillant pour un manufacturier de portes et châssis \u2014 Carpenter-joiner and painter working for a door-window manufacturer.1.25 1.15 Chauffeur dc bouilloires \u2014 Boiler fireman.1.30 1.20 Gréeur \u2014 Rigger.1.40 1.30 Ql 7.7,7 .Y ' 0FF1C 1.1 /, (') Employé: Le mol \"employé\" désigne toute personne salariée de l'un ou «le l'autre sexe qui, subordonnément au paragraphe \"j\" de l'article I de la Loi de la convention collective, travaille pour un employeur t«-l «pic défini au paragraphe \"a\" «lu présent article.c) Employé régulier: Le ternie \"employé régulier\" désigne tout employé qui fait la semaine régulière de travail «le l'établissement où il est employé.(7) Employé supplémentaire: Le terme \"employé supplémentaire\" «lésigne tout employé qui est embauché en plus du personnel régulier, «l'une façon intermittente, durant la semaine normale dc travail.c) Messager (Commissionnaire): Le mot \"messager\" désigne tout employé qui exécute le travail reconnu comme celui de messager ou commissionnaire, et.fait la livraison, soit à pied, soit à bicyclette./) Caissier ou caissière: Le mot \"caissier\" ou \"caissière\" désigne tout, employé qui perçoit l'argent venant «les ventes «'t exécute tout autre travail qui est ordinairement fait par le caissier ou la caissière.g) Commis: Le mot \"commis\" désigne tout employé préposé à la perception, à la réceoption, à l'étalage, à l'étiquetage, au déballage ou à remballage, à l'entreposage, à la vente et à l'expédition des marchandises, au débitage, à la préparation et à la vente «les viandes.//) Employé de bureau: Le terme \"employé dc bureau\" désigne tout employé qui, faisant le travail clérical de bureau, la correspomlance, la tenue des livres, etc., n'est pas autrement désigné dans le décret.i) Livreur: Le mot \"livreur\" désigne tout employé qui, au moyen «l'une voiture à traction animale ou d'une voiture automobile dont il a la charge, fait la livraison et le transport des marchandises à tout endroit déterminé par l'employeur.Le livreur, à ses moments libres, doit travailler à tout ouvrage requis par son em-.ployeur «lans l'établissement.j) Aide-livreur: Le terme \"aide-livreur\" désigne tout employé qui aide le livreur à faire la livraison et le transport des marchandises.L'aide-livreur à ses moment libres, doit aider dans l'établissement.k) Apprenti: Le mot \"apprenti désigne toute personne qui n'a aucune expérience comme employé de magasin dc commerce de détail.IL Juridiction: a) Commerciale: sont assujettis au décret, tous les établissements commer- It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, Til.tT the said petition be accepted in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Stalules of Quebec 1011.chapter 103 and amendments) with, however, the following new provisions to be substituted for the conditions described in (he (jucha- Official Gazette, issue of October 2!), 111.\").\").I.Definitions: For the purposes of the «lecree, the following terms have the meaning hereinafter given to them : a) Employer: The word \"employer\" means any person, association or corporation who.subordinate^ to subsection \"/\" and \"g\" of section I of the Collective Agreement Act, keeps or Operates one or more commercial establishments or private concerns in which any one of the trades governed by the decree is operated on a retail basis or on a wholesale and retail basis, whether such trade constitutes the main trade or an accessory to any other trade or occupation.b) Employas: The word \"employee\" means any wage-earning person of either sex, who at ordinately to subsection \"j\" of section I of the Collective Agreement Act, works for an employer as defined in subsection \"«\" of the present section.c) Regular employee: The words \"regular employee\" mean any employee who works the rgu-lar working week of the establishment in which he is employed.d) Extra employee: The words \"extra employee\" mean any employee who is hire«l in addition to the regular staff, intermittently, in the course of the normal work week.c) Messenger (Errand boy): The work \"messenger\" means any employee who performs work usually known as that of messenger or errand by and delivers goods either on foot or with a bicycle./) Cashier: The word \"cashier\" means any male or female employee who collects the money from the sales and perforins any other work usually done by a cashier.g) Cleric: The word \"clerk\" means any employee doing the collection, the receiving, labelling, displaying, storing, sale, packing and unpacking and shipping of goods, including the cutting, preparation and sale of meat.h) Office employees: The words \"office employee\" mean any employee who does office clerk work, correspondence, bookkeeping, etc., and is not otherwise designated in the decree.i) Delivery man: The words \"delivery-man\" mean any employee who, with a horse-drawn or motor vehicle entrusted to his care, does the delivery ami transport of goods to any place designated by the employer.The delivery man, in his spare moments, shall work at the general maintenance of the establishment.j) Delivery man's helper: The words \"delivery man's helper\" mean any employee who helps the delivery man in the delivery and transport of goods.The delivery man's helper, in-his spare moments, sahll do general work./\u2022) Apprentice: The word \"apprentice\" means any person who has no experience as retail store employee.II.Jurisdiction: a) Commercial jurisdiction: Shall be subject to the decree, all commercial 4026 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 ciaux qui font le commerce «le détail ou le commerce dc gros et de détail, qu'ils aient un établissement de commerce ordinaire ou qu'ils n'aient qu'un ou des agents ou bureaux dans les limites de la juridiction territoriale «lu présent décret.Toutefois, le décret ne s'applique pas aux pharmacies, magasins de journaux, optomé-tristes, fleuristes et à tout autre commerce déjà régi par un autre décret.b) Territoriale: Le «lécret s'applique à la ville dc Magog et à tout le territoire compris dans un rayon de cinq (ô) milles dc ses limites.III.Durée du travail: Les heures du commencement et de la fin du travail régulier sont les suivantes: a) Épicerie, boucherie et épicerie-boucherie: Les lundi, mardi, jeudi et samedi: «le 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le mercredi: dc 8.00 a.m.à midi trente (30) minutes.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.b) Vêtements et nouveautés: Les lundi, mardi, jeudi et samedi,de8.30 a.m.à 6.00 p.m.Le mercredi: dc 8.30 a.m.à midi.Le vendredi: «le 8.30 a.m.à 10.00 p.m.c) Quincaillerie, meubles, appareils électriques: Les lundi, mardi, jeudi et samedi: dc 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le mercredi 8.00 a.m.à midi.Le vendredi: dc 8.00 a.m.à 10.00 p.m.Note: Le personnel féminin commence le travail à 8.30 a.m.et le termine aux mômes heures que le personnel masculin.d) Toutefois, lorsque dans la semaine, il y a une fête chômée, les heures de travail sont de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.le mercredi.c) Tout travail exécuté après les heures régulières, sauf les vingt (20) minutes nécessitées pour le service de la clientèle et la mise en onlrc du magasin, est considéré temps supplémentaire et doit être rémunéré au taux et demi./) L'employeur doit accorder chaque jour à ses employés, une (1) heure pour le repas du midi et de plus une (1) heure pour le repas du soir, le vendredi.g) Dans le cas d'urgence où les employés doivent travailler pendant leur période régulière des repas, l'employeur doit leur allouer ce même temps aussitôt que possible, dès que l'état «l'urgence a cessé et, à tout événement, pas plus tard qu'une (1) heure après la période régulière des repas.k) Durant la période des fêtes dc Noël et du premier jour de l'An, le travail peut se continuer jusqu'à 10.00 p.m.: 1° Dans les épiceries, boucheries ou épiceries-boucheries: les 21, 22, 23, 29 et 30 décembre.2° Dans tous les autres établissements commerciaux assujettis: du 15 au 30 décembre inclusivement.Réserve: Nonobstant les disposition du décret, la durée des heures de travail dans les établissements commerciaux ne doit en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de la Loi des Établissements Industriels et Commerciaux (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 175) aux décrets faits sous son autorité et aux règlements établis par les municipalités compétentes.IV.Taux de salaire minima: Les taux de salaires minima sont les suivants: establishments engaged in the retail trade or in the wholesale and retail trade, whether they have a regular commercial establishment or one or several agents or offices within the territorial limits «>f the present decree.However, the decree shall not apply to drugstores, news-stands, optometrists, florists nor to any other trade already regulated by another decree.b) Territorial jurisdiction: The decrree applies to the town of Magog and to the territory comprised in a radius of five (5) miles from its limits.III.Duration of work: The regular starting and finishing times shall be as follows: a) Groceries and lor butcher shops: Monday, Tuesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.* to 6.00 p.m.Wednesday: 8.00 a.m.to 12.30 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.b) Clothing and novelties : Monday, Tuesday, Thursday and Saturday: 8.30 a.m.to 6.00 p.m.Wednesday: 8.30 a.m.to 12.00 (noon) Friday: 8.30 a.m.to 10.00 p.m.c) Hardware, furniture, electrical appliance: Monday, Tuesday, Thursday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Wednesday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon) Friday: 8.00 a.m.to 10.00 p.m.Note: Female employees shall start at 8.30 a.m.and finish at the same time as male employees.d) When a holiday falls in a week, however, Wednesday is worked all day from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.e) All time worked beyond the regular hours, excepting the twenty minutes required to wait on customers and set things to rights in the store, shall be considered as overtime and paid at the rate of time ami one half./) Employers shall, every day, give one hour off to his employees for the noon meal and, on Friday, they shall give one hour for the evening meal.g) In cases of emergency where employees must work through their regular meal periods, employers shall give the same period of time off as soon as the emergency has ceased to exist but no later than one hour after the regular meal period.h) During the Christmas and New Year's Holidays period, time may be worked until 10.00 p.m.: 1.by grocers and/or butchers: on December 21, 22, 23, 29 and 30; 2.by the other trades governed: from December 15 to December 30 inclusive.Proviso: Norwithstinding the provisions of the decree, the duration of working hours in the commercial establishments shall never constitute a violation of the provisions of the Industrial and Commercial Establishments Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 175), of the decrees enacted under its authority and of the regulations made by authorized municipalities.IV.The following shall\\be the minimum wage rates : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4027 a) Épicerie, boucherie ou épicerie-boucherie: Classification: par semaine Commis-bouclier et acheteur.$40.00 Commis-boucher.35.00 Apprenti : Premiers six (0) mois.20.00 Après six ((>) mois.25.00 Après dix-huit (18) mois.30.00 Après trente (30) mois.35.00 Commis épicier, premier commis ou commis en charge.35.00 Apprenti: Premier six (G) mois.20.00 Après six (6) mois.25.00 Après dix-huit (18) mois.30.00 Caissière.25.00 Commissaire.15.00 b) Vêtements et nouveautés: 1° Classification: Commis expérimenté (homme).35.00 Commis expérimenté (femme).30.00 Commis sans expérience (homme et femme).22.00 Couturière (expérience deux (2) ans et plus.25.00 2° Les employés sans expérience, recevant moins que le salaire minimum des employés avec expérience, ont droit à une augmentation de salaire de deux (82.00) dollars tous_ les six (6) mois, jusqu'à concurrence du salaire minimum des employés expérimentés.c) Quincaillerie, meubles et appareils électri- ques: Classification: Commis acheteur, homme.$15.00 Commis acheteur, femme.35.00 Commis d'expérience.30.00 Commis sans expérience.22.00 Livreur (camion).35.00 d) Employés supplémentaires: l'heure Commis, homme.0.70 Commis, femme.0.00 V.Fêtes chômées et payées: Les jours suivants sont des jours de fêtes chômées et payées : Le premier jour dc l'An, le 2 janvier, l'Epiphanie, le Vendredi Saint, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, Ja Confédération, la Fête du Travail, la Toussaint, l'Immaculée Conception, Noël et le 26 décembre.Note: Nonobstant ce qui précède relativement aux fêtes chômées et payées, il est convenu que : i.si un ou plusieurs de ces jours de fêtes tombent un dimanche, ce jour ou ces jours sont considérés comme un dimanche et ne sont pas rémunérés; ii.dans le cas des épiceries, boucheries^ ou épiceries-boucheries, le 26 décembre et le 2 jan-vierne sont pas chômés dans tous les cas où ceci aurait comme conséquence la fermeture des magasins une troisième journée consécutive; iii.les jours déclarés fériés par proclamation municipale, provinciale ou fédérale sont des jours chômés mais non rémunérés.VI.Vacances payées: a) Tous les employés qui ont travaillé pour leur employeur pendant un (1) an ou plus ont droit à six (6) jours consécutifs de vacances payées.b) Les employés qui ont moins d'un an de service pour leur employeur à la date des vacances, a) Groceries andfor butcher shops: Classification: Minimum rates per week Butcher clerk and buyer.$40.00 Butcher clerk.35.00 Apprentice : 1st six months.20.00 after six months.25.00 after eighteen months.30.00 after thirty months.35.00 Grocer clerk, head clerk or clerk in charge.35.00 Apprentice : 1st six months.20.00 after six months.25.00 after eighteen months.30.00 Sashier.25.00 Errand boy.15.00 /;) Clothing and novelties : 1) Classification : Experienced clerk (male).35.00 Experienced clerk (female).30.00 Inexperienced clerk (male or female) .22.00 Seamstress (two or more years of experience).25.00 2.Inexperienced employees receiving less than the minimum wages established for inexperienced employees shall be entitled to a wage increase of two (82.00) dollars every six months to the extent of the minimum wages established for inexperienced employees.c) Hardware, furniture and electrical appliances: Classification: Clerk and buyer, male.845.00 Clerk and buyer, female.35.00 Experienced clerk.30.00 Inexperienced clerk.22.00 Delivery man (truck).35.00 c7) Occasional employees: per hour Male clerk.!.0.70 Female clerk.0.60 V.Holidays with pay: The following shall be holidays with pay: New Year's Day, the day after New Year's, Epiphany, Good Friday, Ascension Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day, Labour Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day, Christmas Day, the day after Christmas.Note: Notwithstanding the foregoing in respect of holidays with pay, it is agreed that: i.should one or more such holidays fall on a Sunday, such day or days shall be considered as a Sunday and shall not be remunerated; ii.as regards groceries and/or butcher shops, December 26and January 2nd shall not be observed as holidays when they cause the closing of the store for a third consecutive day.iii.days proclaimed as holidays by the municipal, provincial or federal governments shall not be worked but shall not be remunerated.VI.Vacations with pay: a) Sll employees who have worked for an employer during one (1) year or more shall be entitled to a vacation of six consecutive days with pay.b) Employees who have worked for the employer during less than one year at the time o 4028 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1955, Tome 87, N° 52 ou qui le quittent durant l'année, ont droit à 2% du salaire gagné.c) Tous les employés qui ont travaillé pour le même employeur pendant cinq (5) ans ou plus, ont droit à une deuxième semaine de vacance payée à la condition que le total des absences et de retards à l'ouvrage durant l'année ne compense pas pour les six (0) jours additionnels.Dans le cas où, il n'y aurait pas compensation totale, l'employé a droit à la partie dc cette deuxième semaine non entamée par ses absences et ses retards.La date de cette deuxième semaine de vacances ou partie d'icelle, est fixée par entente entre l'employeur et l'employé.d) Les employés choisissent la date de leurs vacances par ordre d'ancienneté.e) Les dimanches et les jours de fêtes mentionnés à l'article V ne doivent pas être considérés comme des jours de vacances payées./) Les salaires pour la période des vacances doivent être payés d'avance aux employés.g) La période donnant droit aux vacances s'étend du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.VIL Uniforme: Si l'employeur exige le port d'un uniforme, dc tabliers ou autres vêtements spéciaux, le coût du lavage et de l'entretien est réparti également entre l'employeur et l'employé.VIII.Privilège ou avantagea: Aucune des dispositions du décret ne peut être interprétée de façon à faire perdre aux employés les privilèges ou avantages aux quels ils ont droit présentement, même s'ils ne sont pas stipulés dans le décret.IX.Durée du décret: Le décret entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 1er septembre 1956.II se renouvelle automatiquement, d'année en année, par la suite à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit de son intention d'y mettre fin, dans un délai de pas plus «le soixante (60) jours ni de moins de trente (30) jours avant, l'expiration du terme original ou «le toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.L.DÉSILETS, 41462-0 * Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers (Sec.P.1626-37) Avis est donné que, sur la recommantlation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le douze décembre,1955, les amendements apportés aux articles VI et XI des règlements du \"Kiwanis Club of Quebec Incorporated\", tels qu'adoptés aux assemblées tenues les 13 novembre 1952 et 3 novembre 1955, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire dc la province le quinze décembre 1935.Le Sous-secrétaire de la province, 41449-0 JEAN BRUCHÉSI.vacations, or employees who leave the employer during the year, shall be entitled to 2% of the wages earned.c) Employees who have worked for the employer during five (5) years or more shall be entitled to a second week of vacation with pay providing absences and lateness to work during the year do not compensate for the six additional days.In the event of the compensation not being total, employees shall be entitled to that part of the second week not affected by absences or lateness to work.The period of vacation as regards this second week, or part thereof, shall be set upon agreement between the employer and the employee.d) Employees shall choose the date of their vacation by order of seniority.e) These days of vacation shall not include Sundays and the holidays above mentioned in section V./) Vacation pay shall be given to employees in advance.g) The period giving the right to the vacation shall exteml from May 1st of one year to April 30th of the following year.VII.Clothes: Should special clothes, uniforms or aprons be required by the employer, the cost of laundering and maintenance shall be divided equally between the employer and the employee.VIII.Privileges or advantages: The enforcement of the decree shall not affect the privileges or advantages not mentioned in the decree but to which the employees are now entitled.IX.Duration of the decree: The decree shall come into force on the «latc of its publication in the Quebec Official Gazette and remain in force until September 1st, 1956.It shall then renew itself automatically from year to year, unless one of the contracting parties notifies the other party to the contrary within the period extending from the sixtieth to the thirtieth day before the expiration of the original term or of any subsequent year.Such a notice shall also be filed with the Minister of Labour.L.DÉSILETS, 41462-0 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices (P.Sec: 1626-37) Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on December twelfth 1955, the amendments to articles VI and XI of the by-laws of \"Kiwanis Club of Quebec Incorporated\", as adopted at meetings held on November 13th, 1952 and November 3rd, 1955, and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the fifteenth day of December, 1955.JEAN BRUCHÉSI, 41449 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1965, Vol.87, No.52 4029 Loi du Régime des Eaux Courantes, Chapitre 98, S.R.Q., 1941.Avis de la demande Dl DÉPÔT de Plans et Devis Avis est donné au publie conformément à l'article 00 de la Loi du Régime des Eaux Courantes que la \"Pembroke Electric Light Company Limited\", de la ville de Pembroke, dans la Province d'Ontario, et ayant une place d'affaires dans le Canton de Waltham, comté de Pontine, Province de Québec, se propose de faire faire des travaux consistant dans un barrage et autres autres accessoires pour l'eminagasinement, en toutes saisons, des eaux du Lac Balsam, dans le district de Pontine, dans le but de les conserver pour en régulariser le débit et assurer aux usines de ladite compagnie dans le canton de Waltham la constance des forces hydrauliques.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant l'emplacement de ces travaux et les terrains qui seront affectés par ces travaux, a été transmise au Ministre des Terres et Forêts, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la Division d'Enregistrement du comté de Pontiac, à Campbell's Bay.La demande d'autorisation contenue dans la requête sera prise en considération par le Lieutenant-gouverneur en Conseil le ou après le dixième jour suivant la date dc la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Hull, le 20 décembre 1955.Pembroke Electric Light Company Limted, Par: Le Président, W.R.BE ATT Y.(Sceau) Le Secrétaire, 41440-o H.J.CLAUSON.AVIS Par ordre du Bureau Provincial de Médecine, en date du 20 décembre 1955, le docteur Francois Bélanger, médecin demeurant au numéro 2341 est, rue Ontario.Montréal, est destitué comme membre du Collège des Médecins et Chirurgiens de la Province de Québec, pour avoir été condamné par le Juge Municipal de Westmount à deux années de pénitencier, le tout conforme au paragraphe 2, article 07, chapitre 264 (Loi Médicale du Québec).Montréal, le 21 décembre 1955.Le Collège des Médecins et Chirurgiens de la Province de Québec, par le Régistraire, 41448-0 JEAN PAQUIN, M.D.Avis est par les présentes donné par les soussignés que le lieutenant-gouverneur en conseil a adopte, en date du lf> décembre 1955, un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom tic la municipalité de la paroisse de Saint-Bonaventure-dc-Hainilton, en celui de \"municipalité de Bona-venture\", comté dc Bonaventure.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter dc la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Bonaventure.21 décembre 1955.Le Maire, E.A.ARSENAULT.Le Secrétaire-trésorier.41460-o J.-CHS.ARSENAULT.Water-Courses' Act Chapter 98, R.S.Q., 19/, 1 Notice ok application and Deposit of Plans and Specifications Public notice is hereby given in accordance with section 00 of the Watcr-Courxs' Act that the Pembroke Electric Light Company Limited, of the town of Pembroke, Province of Ontario, and having a place of business in the township of Waltham, district of Pontiac.intends to build a dam and execute other accessory works for the storing, at all seasons, of the waters of Balsam Lake, in the district of Pontiac, with the object of conserving said waters so as to regulate their flow and thus ensure a uniform supply and assure to the company's plant in the township of Waltham a constancy of hydraulic power.Notice is also given that a Petition to thai effect, accompanied by plans and specifications showing the site and the nature of the works or of the improvements, and the land which is affected by such works, has been forwarded to the Minister of Lands and Forests, and thai a duplicate of such plans and specifications has been deposited at the Registry Oflice of the Registration Divisions of Pontiac at Campbell's Bay.The application contained in the Petition will be taken into consideration by the Lieutenant-Governor in Council on or after the tenth day following the date of the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Dull, December 20t'h.1955.Pe.mukoke Electkic Light, Company Limited, per: W.R.BEATTY, President.(Seal) II.J.CLAUSOX.41440-o Secretary.NOTICE By an order of the Provincial Medical Board, dated Dcdeinber 29th, 1955, Doctor François Bélanger, physician residing at.number 2341 Ontario Street, East.Montreal, has been dismissed as member of the College of Physicians and Surgeons of the Province of Quebec, for having been sentenced by the Municipal Judge of Westmount to two years penitentiary, all of which pursuant to paragraph 2, section 67, chapter 264 (Quebec Medical Act).Montreal, December 21st, 1955.The College of Physicians and Surgeons of the Province of Quebec.Per JEAN PAQUIN, 41448 Registrar.Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted, on December 15th, 1955.an Order in Council in order to change the name of the municipality of the parish of Saint Bonavcnture-de-IIaniilton.to that of \"Municipality of Bonaventure\", county of Bonaventure.Pursuant to the provisions of article 48 of the municipal Code, this change of name shall come into force as from the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Bonaventure, December 21st, 1955.E.A.ARSENAULT, Mayor.J.-CHS.ARSENAULT, 41460 Secretary-Treasurer. 4030 G.iZ'ETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 (P.G.13353-55) Progress] ve Finance Corporation Limited Règlement Spécial \"A\" (qui augmente le nombre des directeurs de t rois a neuf) \"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction composé de neuf directeurs dont cinq formeront quorum\".Je, Fernand Lareau, secrétaire-trésorier de \"Progressive Finance Corporation Limited\", certifie, par les présentes, que le précédent est une copie conforme et exacte du règlement spécial \"A\" décrété par le bureau de direction à son assemblée tenue le 28e jour de novembre 1055, en la cité de Mont réal, province de Québec, et ratié et confirmé à une assemblée des actionnaires de la compagnie tenue le 28e jour de novembre 1955, à laquelle les détenteurs de toutes les actions émises de la compagnie étaient présents en personne et votèrent à l'unanimité en faveur de la sanction et ratification dudit règlement.Montréal.Québec, 30 novembre 1955.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 41450 FERNAND LAREAU.Avis est par les présentes donné par les soussignés que le Lieutenant-gouverneur eu conseil a adopté, en date du 15 décembre 1955, un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom «le la municipalité du canton de Ashford, comté dc lTslet, en celui dc \"municipalité de Saint-Damase-de-lTslct\", comté «le lTslet.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication «lu présent avis dans la Gazelle officielle de Québec.St-Damasc «le lTslet, 21 décembre 1955.Le Maire, ARMAND GAM ACHE, I .e Secrétaire-trésorier.41401-o MARC FORTIN.AVIS (Loi «les syndicats professionnels La formation d'une société, sous le nom «le \"Les Employés «le United Paper Box Co.Limited.Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux, et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province, le vingt-huit décembre 1955.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé en la cité du Cap-de-la-Madeleine, district jmliciaire des Trois-Rivières.Le Sous-secrétaire de la Province, 41472-0 JEAN BRUCHÉSI.Chartes \u2014 Abandon de conserveries DoRION LlMITKE Dorion Preserving Limited Avis est par les présentes donné que \"Con-serverie Dorion Limitée \u2014 Dorion Preserving Limited\", corporation légalement constituée en vertu de la Loi des Compagnies de Québec et ayant sa place d'affaires dans la cité de Mont- (A.G.13353-55) Progressive Finance Corporation Limited Special By-law \"A\" (increasing the number of directors from three to nine) \"The affairs of the company shall be managed by a board of nine directors, five of whom, shall form a quorum\".I, Fcrnand Lareau, Secretary-Treasurer of \"Progressive Finance Corporation Limited,\" do hereby certify the foregoing to be a true and exact copy of Special By-law \"A\" enacted by the Board of Directors at its meeting held on the 28th day of November, 1955, at the city of Montreal, Province of Quebec, ami ratified and confirmed at a meeting of the Shareholders of the Company held out the 2«Sth day of November 1955, at which were present in person the holders «>f all the issued shares of the Company who voted unanimously in favour of sanctioning and ratifying the said By-law.Montreal, Quebec, November 30th.1955.(Seal) FERNAND LAREAU, 41450-o Secretary-Treasurer.Notk \u2022e is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted, on December 15th, 1955, an Order in Council in order to change the name of the municipality of the township of Ashford.county «>f lTslet, to that of the \"Municipality of Saint-Damase-de-lTslet\", county of I'Islet.Pursuant to the provisions of article 48 of the Municipal ('ode, this change of name shall come into force as from the time of publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Saint Dnmase-«le-l'Islet, December 21st 1955.ARMAND GAMACHE, Mayor.MARC FORTIN, 41401 Secretary-Treasurer.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Les Employés «le United Paper Box Co.Limited.Inc.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its membres, has been authorized by the Provincial Secretary on twenty-eighth day of December, 1955.The principal place of business of the said professional syndicate is in the city of Cap de la Madeleine, judicial district of Three Rivers.JEAN BRUCHÉSI, 41472 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of Conserverie Dorion Limitée Dorion Preserving Limited Notice is hereby given that the \"Conserverie Dorion Limitée \u2014 Dorion Preserving Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney- QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec, December 81st, 1955, Vol.87, No.62 4031 real, présentera une requête au Procureur Général de la Province de Qiirl.ee aux (ins d'abandon de ses lettres patentes, le toul suivant les 'li-position dc ladite Loi des Compagnies de Québec.Fait à Montréal, ce 27c jour dc décembre 1955.Le Secrétaire.41471-0 (signé) JACQUES COUVRETTE.L'Oeuvre du Foyer Avis est par les présentes donné (pie la Compagnie \"L'Oeuvre du Foyer\", incorporée en février 1013.sous la partie 3 de la Loi Provinciale des Compagnies, s'adressera au Lieutenant gouverneur de la Province de Québec, pour l'abandon de sa charte.Montréal, le 22 décembre 10.\").\").Le Procureur de la requérante, 41459-0 YVES LAURIER, C.R.Compagnies dissoutes (P.G.12281-65) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 26.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plus au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Chas.IL Turner & Co.Ltd.\", constituée cneorporation par lettres patentes en date du 31 juillet 1011.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1955.L'Assistant -procureur général.41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.11070-0.-)) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 27(5 article 26.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 dc ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Harpe! Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 mai 1040.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1955.L'Assistant -procureur général, 11 I30-o C.E.CANTIN.(P.G.12777-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1041.chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Jordan Sportswear Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 mai 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1955, ladite compagnie a été dissoute.General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 27th dav of December, 1955.(signed) JACQUES COUVRETTE, 41471-o Secretary.L'Oeuvre du Foyer Notice is hereby given that the Company \"L'Oeuvre du Foyer\", incorporated in February 1943, under Part 3 of the Quebec Companies' Act, shall apply to the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, December 22nd.1955.YVES LAURIER, Q.C., 41459 Attorney for the petitioner.Companies Dissolved (A.G.12281-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20.chapter 276, R.S.Q.1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept, the surrender of the charter of the company \"Chas.II.Turner is: Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated July 31st, 1944.Notice is also given that from and after the fifteenth day of December 1955, the said company has been dissolved.Dated at the oflice of the Attorney General, this sixteenth dav of December.1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.11975-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 26, chapter 276, R.S.Q., 1911, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Harpel Limited\", incorporated by letters patent dated May 4th, 1949.Notice is also given that from and after the fifteenth day of December.1955, the said company has been dissolved.Dated at the oflice of the Attorney General, this sixteenth dav of December.1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12777-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26.chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been plased to accept the surrender of the charter of the company \"Jordan Sportswear Incorporated\", incorporated by letters patent date May 21st, 1946.Notice is also given that from and after December fifteenth 1955, the said company has been dissolved. \u20221032 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-o C.E.CANTIN.(P.G.12217-55) Avis est donné qu'en vertu de la première parlie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon dc la charte de la compagnie \"Les Entrepôts dc l'Est Limitée \u2014 Eastern Storage Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 mars 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1955.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41439-o C.E.CANTIN.(P.G.10941-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Les Immeubles Marquis Ltée \u2014 Marquis Realties Ltd\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 février 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.(P.G.11970-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 276, article 20.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Rawin (\"oustruction Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 août 1953.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1955, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41439-0 C.E.CANTIN.Demandes à la Législature Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.12217-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 26.chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been plascd to accept the surrender of the charter of the company \"Les Entrepots de l'Est Limitée \u2014 Eastern Storage Limited\", incorporated by letters patent dated March 24th, 1948.Notice is also given that from and after December fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.10941-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26 chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Les Immeubles Marquis Ltée \u2014 Marquis Realties Ltd\", incorporated by letters patent dated February 11th, 1954.Notice is also given that from and after December fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.(A.G.11970-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Rawin Construction Ltd.\", incorporated by letters patent dated August 24th, 1953.Notice is also given that from and after December fifteenth 1955, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41439 Deputy Attorney General.Applications to Legislature Avis est par les présentes donné, que la ville de Richmond s'adressera à la présente session pour obtenir la passation d'une loi amendant sa charte la Loi I Edouard VII, chapitre 50 et les divers status qui l'amendent, sur les matières suivantes: permettre de fixer l'évaluation des immeubles industriels de Richmond Plastic Co.Limited à la somme de cinquante mille dollars pour une période dc cinq ans à compter du 1er janvier, 1956; pour être autorisée à emprunter une somme n'excédant pas deux cent cinquante Notice is hereby given that the Town of Richmond will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an act amending its charter, the act I Edward VII, ch.50, and the various statutes amending it: to allow to fix the valuation of the industrial immoveable properties of Richmond Plastic Co.Limited to the sura of fifty thousand dollars for a period of five years starting from the first day of January 1956; to be authorized to borrow by by-law an amount QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 3ht, 1955, Vol.87, No.52 4033 mille dollars pour acquérir ou construire des immeubles devant servir à des fins municipales ou industrielles; pour amender l'article 593 de la Loi des cités et villes pour porter de six à quinze le nombre des électeurs propriétaires demandant qu'un règlement d'emprunt soit soumis pour approbation aux électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables; et pour d'autres fins.Sherbrooke, ce 30 novembre, 1955.Le Procureur de la requérante, 41336-49-4-0 LÉONCE CÔTÉ, C.R.Avis est par les présentes donné que Joseph Sabbath, Docteur en médecine de la cité de Boston, état du Massachusetts, un des États-Unis d'Amérique, et le Royal Trust Company, corps politique et incorporé ayant son bureau et sa principale place d'affaires dans les cité et district de Montréal, en leur qualité d'exécuteur testamentaires et fiduciaires de la succession de feu Jean Louis Sabbath, de son vivant marchand, des cité et district de Montréal, fera appel à la Législature de la province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi autorisant les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires de ladite succession, pour terminer, compromettre et transiger sur le litige actuellement pendant devant la cour Suprême du Canada entre ladite succession et Dame Béatrice Norma Sabbath, ménagère, de la cité d'Ottawa, province d'Ontario, épouse séparée de biens de Samuel R.Hock, suivant les termes et conditions et pour les considérations plus amplement détaillées dans l'acte de transactions passé devant le notaire Paul Poirier, le 3 décembre 1955, et portant le N° 7910 de ses minutes, nonobstant toutes clauses au contraire qui peuvent être contenues dans ledit testament dudit Jean Louis Sabbath, et pour confirmer, ratifier et déclarer valide le présent acte de transaction à toutes fins que de droit.Montréal, le 3 décembre 1955.Le Procureur du requérant.41341-49-4-0 MARC-ANDRÉ BLAIN.Avis public est, par les présentes, donné que ('\"Institut des Auditeurs Publics Accrédites\", corps politique et incorporé, et \"The International Society of Commerce Limited\", corps politique et incorporé, s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi modifiant la Loi pour réglementer la pratique de la comptabilité et de la vérification (loi 10 George VI, chapitre 47, amendée par la loi 11 George VI, chapitre 64), afin de permettre aux candidats à l'\"Institut des Comptables Agréés de la Province dc Québec\" de faire leur cléricature dans un bureau d'un membre qualifié de T'Tnter-national Society of Commerce Limited\" (A.P.A.) et déclarer telle cléricature valide; et pour autres fins.Québec, le 5 décembre 1955.Le procureur des pétitionnaires, 41350-49-4-o LOUIS LAROCHE.AVIS Requête à la Législature de Québec Avis public est par les présentes donné que Bishop's College, une corporation constituée par not exceeding two hundred and fifty thousand dollars to acquire or build immoveables which shall serve for municipal or industrial purposes; to amend article 593 of the law of cities and towns to increase from six to fifteen the number of electors owners asking that a by-law of loan be submitted for approval to the electors owners of immoveable properties and for other purposes.Sherbrooke, November 30th, 1955.LÉONCE CÔTÉ, Q.C., 41336-49-4-0 Attorney for petitioner.Public notice is hereby given that Joseph Sabbath, Doctor of Médecine, of the city of Boston in the Commonwealth of Massachusetts, one of the United States of America, and the Royal Trust Company, a body politic and corporate, duly incorporated according to law and having its Head Office and principal place of business in the city and district of Montreal, in their quality as testamentary executors and trustees of the Estate of the late John Louis Sabbath, in his lifetime merchant of the city and district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act, authorizing the testamentary executors and trustees of the said estate to settle, compromise and transact the litigation presently pending before the Supreme Court of Canada between the said Estate and Dame Béatrice Norma Sabbath, housewife of the city of Ottawa in the Province of Ontario, wife separate as to property of Samuel R.Hock, upon the terms and conditions and for the considerations more fully set out in that certain agreement of settlement passed before notary Paul Poirier on the 3rd of December 1955 and bearing No.7910 of his Minutes, notwithstanding any provisions to the contrary which may be contained in the last will and testament of the said John Louis Sabbath, and to confirm, ratify and declare valid the said agreement of settlement for all legal purposes.Montreal, December 3rd.1955.MARC-ANDRÉ BLAIN, 41341-49-4-0 Attorney for the petitioners.Public notice is hereby given that \"The Institute of Accredited Public Accountants\", body politic and corporate, and \"The International Society of Commerce Limited\", body politic and corporate, will apply to the Legisla-lature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending the Act to regulate the practice oi the Accountancy and Auditing (Act 10 George VI, chapter 47, amended by Act 11 George VI.chapter 64), in order to allow the candidates of the \"Institute of Chartered Accountants of the Province of Quebec\" to make their services in an office of a member qualified of the \"International Society of Commerce Limited\" (A.P.A.).and to declare such services valid; and for oth«r purposes.Quebec, December 5, 1955.LOUIS LAROCHE.41350-49-4-o The Attorney for the Petitioners.NOTICE Application to Quebec Legislature Public notice is hereby given that Bishop's College, a corporation incorporated by Act of the 4034 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 1955, Tome 87, N° 52 la loi de la Législature de l'ancienne Province du Canada 7 Victoria, chapitre 49, ayant son bureau chef en la ville de Lennoxcille, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour obtenir une loi modifiant sa charte afin de préciser plus clairement ses pouvoirs tie placement.Daté à Montréal, ce Sièmc jour dc décembre 1955.Les Procureurs du requérant, MtMICHAEL, COMMON, HOWARD, 41376-50-4-o KEIl & CATE.Avis public est, par les présentes, donné que Paul-Emile Laperrière, de la cité de Saint-Laurent, district «le Montréal, s'adressera à la Législature tie la Province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi sur la matière suivante: Obtenir un titre valable sur le lot portant le numéro de subdivision 229 du lot originaire 465 du cadastre de la paroisse Saint-Laurent, et pour autres fins.Montréal, 12 décembre 1955.Le Procureur du requérant, 41397-50-4-o ROBERT HODGE, C.R.AVIS PUBLIC Avis, est par les présentes donné que la Corporation tie la paroisse tie Saint-Léonard de Port Maurice s'adressera à la Législature de la province de Québec à sa présente où prochaine session, pour demander en plus des pouvoirs demandés dans l'avis déjà paru pour que les terrains suivants apparaissant comme chemins publics, rues ou ruelles aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de la Longue Pointe et situés dans les limites de la municipalité sont déclarés être la propriété tie la ville à savoir: a) 42S \u2014 1, 20, 40, 64, 65, 73 et 85: h) 427 \u2014 1, 15, 30, 58, 59, 65.69, 77, 91, 105, 136, 140, 141, 156, 160, 168, 183, 198, 230.234, 235, 262, 266, 274, 301, 328, 372, 376, 377, 395, 399, 407, 425, 443, 478, 479, 4S3, 501, 505, 515, 531, 549, 584, 588, 589, 609, 611, 619, 633, 647, 648, 676, 677, Ces chemins publics, rues ou ruelles pourront, être fermés et la ville pourra consentir à toutes personnes ou corporation un titre valable en échange tie d'autres terrains destinés à servir de chemins publics, rues, ou ruelles.Le Procureur de la pétitionnaire, 41395-50-4-o YVES LAURIER.Avis public est, par les présentes, donné que la cité tic Lachinc s'adressera à la Législature tie la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la loi 9 Edouard VII, chapitre 86, en sus des matières décrites à l'avis du 10 novembre 1955, sur les matières suivantes: évaluation, pour fins municipales, tic la troisième usine tie la Northern Electric Company Limited; amender le règlement numéro 1003, concernant le zonage, sans referendum, afin tie permettre certains genres d'industries sur certains lots situés dans la zone 14; abroger l'article 52 du chapitre 86 tic la loi 9 Edouard VII; faire un règlement «le zonage pour tout territoire à annexer, sans referendum; et pour autres fins.Montréal, le 12 décembre 1955.Les Procureurs de la cité tic Laehine.LACROIX, VIAU & POUPART.41396-50-4-o Legislature of the late Province of Canada 7 Victoria, chapter 49, having its head office in the town of Lennoxville, will apply at the present session of the Quebec Legislature for ao Act amending its charter so as to clarify its powers of investment.Dated at Montreal, this 8th day of December 1955.McMICIIAEL, COMMON, HOWARD, KER & CATE, 41376-50-4-o Attorneys for Petitioner.Public notice is, hereby, given that Paul-Emile Laperrière, of the city of Saint-Laurent, district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act, for the following purposes: To obtain a valid title on lot bearing subdivision number 229 of the original lot.number 465 of the official cadastre of the parish of Saint-Laurent ami for other purposes.Montreal, December 12th, 1955.ROBERT HODGE, Q.C.41397-50-4-o Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the Corporation of parish of Saint-Léonard tie Port Maurice will applied to the Legislature of the Province of Quebec, at its present or next session for a passing of an Act for the followings purposes, besides those already published since October 26th, 1955, to with the following lots appearing as public roads, streets, or lanes on the official plan and book of reference of the cadastre of the parish of Longue Pointe and situated in the limits of the Municipality will be declared the town's property: a) 428 \u2014 1, 20, 40, 64, 65, 73 and 85; b) 427 \u2014 1, 15.30, 58, 59, 65, 69.77, 91, 105, 136, 140, 141, 156, 160, 168, 183, 19S, 230, 234, 235, 262, 266, 274, 301, 328, 372, 376, 377, 395, 399, 407, 425, 443, 478, 479, 483, 501, 505, 515, 531, 549, 584, 588, 589, 609, 611, 619, 633, 647, 648.676, 677.With the power for the town to close these public roatls, streets ami lanes ami consents to persons or corporation a valided title to these lots in exchange with other lots destined to serve as public roatls, streets and lanes.YVES LAURTCR, 41395-50-4-o Attorney for the petitioner.Public notice is hereby given that the city of Lachine will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 9 Edward VII, chapter 86, in addition to the purposes described in the notice of November 10th, 1955.for the following purposes: valuation, for municipal purposes, of the Third factory of the Northern Electric Company Limited; to amend by-law number 1003, concerning the zoning, without referendum, in ortler to allow certain types of industries on certain lots situated within the zone 14; to repeal article 52 of chapter 86 of the Act 9 Edward VII; to adopt a zoning by-law for any territory to be annexed, without referendum; and for other purposes.Montreal, December 12th, 1955.LACROIX, VIAU & POUPART, The Attorneys for the city of Lachine.41396-50-4-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4035 Avis est, par les présentes, donné que la ville de Rivière des Prairies, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à la présente ou à une prochaine session pour obtenir l'adoption d'une loi aux fins d'obtenir certains pouvoirs et d'amender sa charte sur les matières suivantes: 1 ° Pour obtenir le pouvoir d'abroger un règlement de zonage et un règlement de construction et d'en adopter de nouveaux sans référendum; 2° Pour faire décréter la propriété à la Ville, à certaines conditions, des rues, ruelles, chemins publics, place publiques et trottoirs actuellement ouverts à l'usage du public dans les limites de la ville ou indiqués comme tels aux plans de subdivision et aux plan et livre de renvoi officiels du Bureau d'Enregistrement de Montréal et au rôle d'évaluation de la ville avant le 1er janvier 1956; 3° Pour permettre à la ville de déterminer pour une certaine période une taxation fixe aux immeubles et terrains de l'usine que s'est engagé de construite J.A.Levine sur le territoire de la ville; 4° Et pour d'autres fins.Montréal, le 9 décembre 1955.Les Procureurs de la pétitionnaire, 41398-50-4-o LABELLE & LABELLE.AVIS PUBLIC Avis est, par les présentes, donné que \"Le Bureau Métropolitain des Ecoles Protestantes de Montréal\" demandera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une Loi, amendant la Loi 15, George V, chapitre 45 et différentes lois l'amendant, aux fins de modier sa charte, étendant et définissant plus amplement ses pouvoirs, et pour d'autre fins.Montréal, ce 13e jour de décembre 1955.Le Procureur des pétitionnaires, 41406-50-4 ALFRED M.WEST, C.R.AVIS PUBLIC Le soussigné donne avis qu'il s'adressera à la Législature de la province de Québec, à la présente session, pour la passation d'une loi autorisant le Barreau de la province de Québec à l'admettre à la pratique du droit.Montréal, le 12 décembre 1955.AKOS DE S.MUSZKA.41418-51-4-0 Canada \u2014 Province de Québec AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que Léonard Dulude, de la paroisse de Varennes, s'adressera à la Législature Provinciale lors de sa présente session pour obtenir une loi le déclarant propriétaire absolu de certains immeubles situés en ia paroisse de Verchères, lesquels immeubles sont connus et désignés sous le numéro deux cent trente et un (231) et certains immeubles situés en la paroisse de Varennes, connus et désignés Premièrement: sous le numéro deux cent trois (203), Deuxièmement: sur partie du lot numéro un 0), Troisièmement: sur le lot numéro deux (2) de ladite paroisse.Le Procureur du pétitionnaire, 41465-52-4-o CHS.M.PIUZE, C.R.Notice is hereby given that the town of Rivière des Prairies will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present or a next session, for the passing of an Act granting certain powers and amending its charter, on the following matters: 1.To obtain the power to abrogate a zoning by-law and a building by-law and to adopt new ones without referendum; 2.To have the property assigned to the town, under certain conditions, of streets, lanes, public roads, public places and sidewalks now open to the use of the public in the limits of the town, or indicated as such on Subdivision Plans, on the Official Plan and Book of Reference deposited at Registry Office of Montreal and on the valuation roll of the town before January 1st, 1956; 3.To authorise the town to set for a pariod of time, a fixed taxation on the land buildings of the factory which J.A.Levine has undertaken to build in the limits of the town; 4.And for other purposes.Montreal, December 9th 1955.LABELLE & LABELLE, 41398-50-4-o Attorneys for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that \"The Protestant School Board of Greater Montreal\" will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, for the passing of an act, amending the Act 15, George V, chapter 45, and various acts amending same, for the purpose of amending its charter, extending and further defining its powers, and for other purposes.Montreal, this 13th day of December 1955.ALFRED M.WEST, Q.C, 41406-50-4-o Attorney for the petioners.PUBLIC NOTICE The undersigned gives notice that he will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit him to the practice of law.Montreal, December, the 12th, 1955.AKOS DE S.MUSZKA.41418-51-4-o Canada \u2014 Province of Quebec PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Leonard Dulude, of the parish of Varennes, will apply to the Provincial Legislature at its present session in order to obtain the passing of an Act declaring him absolute owner of certain immoveables situated in the parish of Verchères, which immoveables arc known and designated as number two hundred and thirty-one (231) and certain immoveables situated in the parish of Varennes, known and designated: Firstly: as number two hundred and three (203), Secondly: on part of lot number one (1), Thirdly: on lot number two (2) of the said parish.CHS.M.PIUZE, Q.C, 41465-52-4 Attorney for the Petitioner. 403G GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, SI décembre 1955, Tome 87, N° 52 Avis est par les présentes, donné, que la ville de Haut cri ve, dans le comté de Saguenay, s'adressera à la Législature dc Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins suivantes: 1° Annexer à son territoire originaire, tel «pic décrit à l'article 2 de la Loi 14, George VI, chapitre 124, le territoire décrit comme suit: Un territoire situé en partie dans la canton de Laflèche, en partie dans le canton dc Mani-couagan et en partie dans le canton de Eudes, comprenant: Dans le canton de Eudes: le bloc B; dans le canton Laflèche: le bloc 1; partie du bloc G; les blocs 8, D et G; rang I, les lots 1 à 13.E, partie du lot F au sud de la rivière Amédée; rang II, les lots 1 à 15; dans le canton de Manicouagan; les blocs D et M; rang VI, les lots 33B à 38B.2° Fixer pour un période de dix (10) ans, à compter de 1956, le montant de taxe municipale payable par Quebec North Shore Taper Company sur tous les biens actuels qu'elle possède et sur ceux qu'elle possédera pour fins industrielles, dans les nouvelles limites de la ville de Hauterive, à la somme de deux mille cinq cents (82,500.00) par année.3° Fixer, pour un période de dix (10) ans, à compter de 1956, le montant de taxe municipale payable par Manicouagan Tower Company sur les biens actuels qu'elle possède et sur ceux qu'elle possédera, pour fins industrielles ou pour fins résidentielles du personnel nécessaire à l'entretien et à l'administration du pouvoir hydroélectrique, dans les limites dc la ville de Haute-rive, à la somme de (85,000) cinq mille dollars, par année.4° Amender sa charte, la loi 14, George VI, chapitre 124, article 9, en augmentant le nombre des échevins de six à huit, à compter des élections générales dc 1957.Baie Comeau, 12 décembre 1955.Les Procureurs de la petit ionnaire, ROULEAU, PARADIS & ROULEAU.41452-52-4-0 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que Trans-Canada Pipe Lines Limited, corporation constituée par statuts du Gouvernement du Canada et ayant son siège social en la cité de Calgary, province d'Alberta, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi lui accordant certains pouvoirs pour les fins de construction de pipe-lines et de transport, de vente et de distribution de gaz naturel dans la province.Montréal, le 24 déceinbre 1955.Le Procureur de la requérante, 41454-52-4-0 JEAN FILION, C.R.Avis est par les présentes donné que Mclchers Distilleries Limited présentera un amendement au projet de loi numéro 114, amendant la charte dc la ville de Berlhierville, pour faire confirmer par la Législature une entente intervenue entre la compagnie et la ville de Berlhierville, relativement à l'évaluation municipale des biens de la compagnie situés dans la ville de Berthierville.Montréal, le 27 décembre 1955.Le Procureur de Melchers Distilleries, Limited, 41470-52-4-o JEAN-PAUL STE-MARIE.Notice is hereby given that the town of Haute-rive, in the county of Saguenay, shall apply to the Legislature of Quebec, at its present session, to request the adoption of an Act for the following purposes: 1.Annex to its original territory, as described in section 2.Act 14, George VI, chapter 124, the territory described as follows: A territory situated partly in the township of Laflèche, partly in the township of Mani-gouagan and partly in the township of Eudes, comprising: In the township of Eudes: Block B; in the township of Laflèche: Block 1; part of Block 6; Blocks 8, D and G; range I, lots 1 to 13, E, part of lot F to the south of the Amédée River; range II, lots 1 to 15; in the township of Manicouagan; Blocks D and M; range VI, lots 33B to 38D.2.To fix at two thousand five hundred dollars (82.500.00) per year, for a period of ten (10) years, as from 1956, the amount of municipal taxation payable by the Quebec North Shore Paper Company on all the actual property the Company holds or shall hold for industrial purposes, within the new limits of the town of Hauterive.3.To fixe at 85,000 (five thousand dollars per year, for a period of ten (10) years, as from 1956, the amount of municipal taxation payable by the Manicouagan Power Company on all the actual property it holds ami on all that it may hold, for industrial purposes or to house the staff required for the maintenance and management of hydroelectric power within, the limits of the town of Hauterive.4.Amend its charter.Act 14, George VI, chapter 124.section 9, by increasing the number of aldermen from six to eight, as from the general elections of 1957.Baie Comeau, December 12th, 1955.ROULEAU, PARADIS & ROULEAU, 41452-52-4 Attorneys for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Trans-Canada Pipe Lines Limited, incorporated by Statutes of the Parliament of Canada and having its head office in the city of Calgary, Province of Alberta, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to ask for the adoption of an Act granting to it certain powers for the purposes of building pipe lines and of transport, sale and distribution of natural gas in the Province.Montreal, December 24, 1955.JEAN FILION, Q.C, 41454-52-4-0 Attorney for petitioner.Notice is hereby given that Melchers Distilleries Limited will present an amendment to Bill No.114, amending the charter of the town of Berthierville, requesting the Legislature to confirm an agreement entered into between the town of Berthierville and the company, in relation to the municipal valuation of the proper-tics of the company, located therein.Montreal, December 27th, 1955.JEAN-PAUL STE-MARIE, Attorney for 41470-52-4-o Melchers Distilleries Ltd. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December Slst, 1955, Vol.87, No.62 4037 Prenez avis que André Langlais, domicilié à Québec, s'adressera à la Législature présentement en Session à Québec afin d'être admis à la pratique du droit.L'Avocat du pétitionnaire.41409-52-4-o LOUIS LANGLAIS.AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné (pie Eileen Mary White, de la cité de Québec, veuve de feu Douglas Watson Ogilvie, de son vivant de la cité de Montréal, courtier en immeubles, John Douglas Ogilvie, de Sidney, Ile de Vancouver, et Lome Frederick Wilson Ogilvie, de l'Ile Bigras, dans la province «le Québec, agent de change, étant les seuls légataires survivants \u2022en vertu du testament dudit feu Douglas Watson Ogilvie, et Montreal Trust Company et ladite Eileen Mary White, les dénis exécuteurs dudit testament, s'adresseront à la Législature dc la province de Québec à sa présente session pour obtenir l'adoption d'une loi autorisant lesdits exécuteurs à faire, à l'occasion, des avances à même le capital de la succession dudit feu Douglas Watson Ogilvie auxdits légataires ou à l'un ou l'autre d'entre eux.Montréal, le 23 décembre 1955.Les Procureurs des requérants, McMICHAEL, COMMON, HOWARD, 41464-52-4-0 KER & CATE.Take notice that André Langlais, having his domicile at Quebec, will petition the Legislature actually sitting at Quebec in order to be admitted to the law practice.LOUIS LANGLAIS, 41469-52-4-0 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Eileen Mary White, of the City of Quebec, widow of the late Douglas Watson Ogilvie, in his lifetime of the City of Montreal, real estate agent, John Douglas Ogilvie, of Sidney, Vancouver Island, ami Lome Frederick Wilson Ogilvie, of He Bigras, Province of Quebec, stockbroker, being the sole surviving legatees under the will of the said late Douglas Watson Ogilvie, and Montreal Trust Company and the said Eileen Mary White, the sole Executors of said will, will apply to the Provincial Legislature, at its present session, for the adoption of an Act to empower said Executors to make advances from time to time out of the capital of the estate of the said late Douglas Watson Ogilvie to said legatees or any of them.Montreal, December 23, 1955.McMICHAEL, COMMON, HOWARD, KER & CATE, 41464-52-4-0 Attorneys for Petitioners.Département de l'Instruction Publique N° 1279-55.Québec, le 23 décembre 1955.Demande est faite d'ériger en municipalité scolaire séparée et distincte, pour des protestants seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire protestante de Fannborough, dans le comté de Rouyn-Noranda', les lots 1 à 32 inclusivement «les rangs I à X inclusivement du canton de Joannes, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41466-52-2-0 0.J.DÉSAULNIERS.N° 627-55.Québec, le 23 décembre 1955.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire protestante de la Cité de Granby, dans le comté tie ShcIFord, pour les protestants seulement, les lots du canton tic Granby qui ont été annexés il la Cité de Granby au 1er janvier 1955.Ce territoire du canton tic Granby est décrit dans l'ordre en conseil N° 781, en date du 28 juillet 1954, qui apparaît à la page 2399 «le la Gazette officielle de Québec, du 7 août 1954.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41467-52-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1126-52.Québec, le 23 décembre 1955.II a plu au Lieutenant-gouverneur en Conseil, par arrête ministériel en date du 15 décembre 1955, dc détacher «le la municipalité scolaire de Stc-Angèle-tlc-Mérici, tlans le comté de Matane, le lot N° 66 du rang VI du canton Fleuriault, pour l'annexer à la municipalité scolaire de Ste-Jeanne-d'Arc, tlans le comté de Matapédia.Cet arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1956.Le Surintendant tie l'Instruction publique, 41468-o O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.1279-55.Quebec, December 23, 1955.Application is made to erect into a separate school municipality, for Protestants only, under the name of \"Thc'Protcstant School Municipality of Farmborough, in the county of Rouyn-Noranda\", lots 1 to 32 inclusive, of ranges I to X inclusive, of the township of Joannes, in the same county.^ 0.J.DÉSAULNIERS, 41466-52-2 Superintendent of Education.No.627-55.Quebec, December 23, 1955.Application is made to annex to the Protestant School Municipality of the City of Granby, in the county of Shcfford, for Protestants only, those lots of the township of Granby which have been annexed to the City of Granby on January first 1955.This territory of the township of Granby is described in Order in Council No.781, dated July 28, 1954, which appears at page 2399 of the Quebec Official Gazette of August 7, 1954.0.J.DÉSAULNIERS, 41467-52-2 Superintendent of Education.No.1126-52.Quebec, December 23, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council tlatetl December 15, 1955, has been pleased to detach from the School Municipality of St.Angèle-dc-Mérici, in the county of Matanc, lot No.66, range VI of township Fleuriault, in order that it be annexed to the School Municipality of St.Jeanne-d'Arc, in the county of Matapédia.This Order in Council shall take effect on July first 1956.0.J.DÉSAULNIERS, 41468 Superintendent of Education. 4038 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1955, Tome 87, N° 52 N° 1003-54.Québec, le 23 décembre 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en Conseil, par arrêté ministériel en date du 15 décembre 1955, concernant l'annexion de certains lots de la municipalité scolaire de St-Josepb de Béranger à celle de Ste-Marie-Médiatricc, dans le comté de Missisquoi, \"de corriger l'item 1 dc l'arrêté en Conseil numéro 1147, en date du 2 novembre 1955, de manière à lire, au lieu des mots \"St-Josepb-de-Beaurivage\", les mots \"St-Joseph-de-Béranger\".Cet arrêté ministériel prend effet immédiatement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41468-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1272-55.Québec, le 23 décembre 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en Conseil, par arrêté ministériel en date du 15 décembre 1955, de changer le nom de la municipalité scolaire du village de St-Martin.dans le comté de Laval, en celui de \"Ville St-Martin\", dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet 8 jours après la publication dc cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41468-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1319-51.Québec, le 23 décembre 1955.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en Conseil, par arrêté ministériel en date du 15 décembre 1955, de corriger l'item 4 de l'ordre en conseil N° 1146, en date du 2 novembre 1955, concernant l'annexion d'un lot à la municipalité scolaire de Sainte-Catherine de Hatley, dans le comté de Stanstead, de manière que la description du lot à annexer se lise comme suit: \"La moitié ouest du lot originaire numéro 23 du rang V du canton de Hatley, portant le numéro 870 du cadastre officiel du canton Hatley\" au lieu de \"le lot 13 du rang V du canton Hatley\".Cet arrêté ministériel prend effet immédiatement.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41468-Q O.1.DÉSAULNIERS.No.1003-54.Quebec, December 23, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased by Order in Council dated December 15, 1955 concerning the annexation of certain lots of the School Municipality of St.Joseph de Béranger to that of St.Marie-Médiatrice, in the county of Missisquoi, to correct item 1 of Order in Council number 1147, dated November 2, 1955, in order that the words \"St.Joseph-de-Béranger\" be read in lieu of the words \"St.Joseph-de-Beaurivage\".This Order in Council shall take effect immediately.O.J.DÉSAULNIERS, 41468 Superintendent of Education.No.1272-55.Quebec, December 23, 1955.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated December 15, 1955, has been pleased to change the name of the School Municipality of the village of St.Martin, in the county of Laval, to that of \"Town of St.Martin,\" in the same county.This Order in Council shall take effect 8 days following the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.O.J.DÉSAULNIERS, 41468 Superintendent of Education.No.1319-51.Quebec, December 23, 1955.His Honour the Lieutenant Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated December 15.1955, to correct Item 4 of Order in Council No.1146, dated November 2, 1955, concerning the annexation of a lot the School Municipality of Saint Catherine de Hatley, in the county of Stanstead, in order that the description of the lot to the annexed shall read as follows: \"The west half of original lot number 23, range V, of the township of Hatley, bearing number 870 of the official cadastre of the township of Hatley\" in lieu of \"lot 13, range V of the township of Hatley\".This Order in Council shall take effect immediately.O.J.DÉSAULNIERS, 41468 Superintendent of Education.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BARREAU DU SAGUENAY \u2014BAR OF SAGUENAY Candidat pour l'étude du droit \u2014 Candidate for the study of law Nom Nam©\tPrénom Surname\t\tAgo\tResidence Residence \t\t\t22\tArvida., \t\t\t\t Chicoutimi, le 21 décembre 1955 \u2014 Chicoutimi, December 21, 1955.41451-0 Sièges sociaux Le Secrétaire du Barreau du Saguenay, RICHARD DUFOUR, Secretary of Saguenay Bar.Head Offices Avis est donné par les présentes que \"L'Asso- Notice is hereby given that \"L'Association dation des Marchands-Détaillants-Québec \u2014 The des Marchands Détaillants-Québec \u2014 The Re- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4039 Retail Merchants' Association-Quebec\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 1er mai 1948, enregistrées le 4 mai 1948, et dont le nom corporatif a été changé en celui de \"L'Association des Marchands Détaillants du Canada-Québec, Inc.\u2014 The Retail Merchants' Association of Canada-Quebec, Inc.\", par lettres patentes su-plémcntaires en date du 11.janvier 1949, enregistrées le 27 janvier 1949, et ayant son bureau principal dans la cité dc Montréal, a établi son bureau du N° 1290 de la rue St-Denis, dans les cité et district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par l'Association comme étant son bureau principal.Montréal, le G décembre 1955.Le Président.41445-0 GÉRALD DALCOURT.tail Merchants' Association-Quebec\" constituted as a corporation under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 1st, 1948 and registered May 4th, 1948, whose corporate name has been changed to that of \"L'Association des Marchands Détaillants du Canada-Québec, Inc.\u2014 The Retail Merchants' Association of Canada-Quebec, Inc.\", by Supplementary letters patent dated January 11, 1949, registered January 27, 1949, and having its head office in the city of Montreal, has established it office at No.1290 St.Denis Street, and the city and district of Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Association as being its head office.Montreal, December 6, 1955.GERALD DALCOURT, 41445 President.Aluminium Construction' Inc.Avis est donné epic la compagnie \"Aluminium Construction Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 novembre 1955, et ayant le principal siège de ses affaires à Montréal, Province de Québec, a établi son bureau à 276 ouest, rue St-Jacqucs, Montréal, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 26 novembre 1955.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier.41441-o SUZANNE LEFEBVRE.Aluminium Construction Inc.Notice is hereby given that \"Aluminium Construction Inc.\", company incorporated by letters patent dated the 24 of November, 1955, and having its chief place of business in Montreal, Province of Quebec, has established its office at 276 St.James Street West, Montreal, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Montreal, November 26, 1955.(Seal) SUZANNE LEFEBVRE, 41441-0 Secretary-Treasurer.Avis dc la situation du bureau principal et de la succursale de la compagnie Newkirk & Co.Ltd (Quebec) Avis est donné que la compagnie \"Newkirk & Co.Ltd (Quebec)\", incorporée en vertu des lettres patentes en date du 22 novembre 1955, a établi son bureau principal au numéro 473 de la rue St.François-Xavier, à Montréal, dans la Province dc Québec, et une succursale au numéro 100 de la rue Adelaide ouest, à Toronto, dans la province d'Ontario.A compter dc la date du présent avis, lesdits bureaux sont considérés par la compagnie comme étant le bureau principal et la succursale dc ladite compagnie.Donné à Montréal, ce 30ième jour de novembre 1955.(Sceau) Newkirk & Co.Ltd (Quebec) par le Secrétaire-trésorier, 41443-0 LESLIE E.WETMORE.Notice of the Situation of the Head Office and branch of Newkirk & Co.Ltd (Quebec) Notice is hereby given that \"Newkirk & Co.Ltd (Quebec)\", incorporated by letters patent on the 22nd day of November 1955, has established its head office at number 473 St.François-Xavier St., Montreal, in the Province of Quebec, and a branch at number 100 Adelaide Street West, Toronto, in the Province of Ontario.From and after the date of this notice, the said offices shall be considered by the company, as being the Head Office and the branch of the company.Dated at Montreal, this 30th day of November, 1955.(Seal) Newkirk & Co.Ltd (Quebec) per: LESLIE E.WETMORE, 41443-o Secretary-Treasurer.AVIS OFFICIEL Le Conseil St-Eustache, N° 1813, des Chevaliers de Colomb de St-Eustache, P.Q., 109 rue St.Nicholas, donne avis par les présentes qu'il possède son siège social à l'adresse ci-dessus indiquée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, ch.134, art.2a) à partir du 22 avril 1953.(Sceau) R.P.COLLETTE, Grand Chevalier.PIERRE GAGNON, 41444-0 Secrétaire Archiviste.OFFICIAL NOTICE The \"Council St-Eustache No.1813, of Knights of Columbus\", of St-Eustache, P.Q., 109 St.Nicholas Street, hereby gives notice that its head office is located at the above-mentioned address and that it is availing itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of ,Quebec (1-2 Elizabeth II, chap.134, sec.2a) as from April 22, 1953.(Seal) R.P.COLLETTE, Grand Knight.PIERRE GAGNON, 41444 Recording-Secretary. 4040 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 31 décembre 1955, Tome 87, N° 62 Canada \u2014 Province dc Québec District dc Trois-Rivières H.Paul Chevalier Inc.Avis est par les présentes donné que \"II.-Paul Chevalier Inc.\", compagnie incorporée en vertu de la première partie de la Loi «les Compagnies de Québec, le 20 avril 1954, a établi son siège social à 552, avenue Mercier en la cité de Shawinigan Falls, district dc Trois-Rivières.Signé à Shawinigan Falls, ce 15 décembre 1955.Le Président, 41446-0 IL P.CHEVALIER.Canada \u2014 Province «le Québec District dc Trois-Rivières Shawinigan Auto Electric Inc.Avis est par les présentes donné que \"Shawinigan Auto Electric Inc.\", compagnie incorporée en vertu dc la première partie de la Loi des Compagnies dc Québec, le 20 décembre 1954, a établie son siège social a 794, 5ième Rue, en la cité de Shawinigan Falls, district «le Trois-Rivières.Signé à Shawinigan Falls, ce 15 décembre 1955.Le Président, 41447-0 RENÉ CLAVET.(P.G.10424-54) Mt-Bruno Construction Inc.Règlement Spécial N° Jt \"Que le siège social de la compagnie présentement situé à 400 me Oak, St-Lambert, soit transporté à 1701 rue Montarville, St-Bruno, Québec.\" Vraie copie.Montréal, 1er août 1955.Le Secrétaire, 41442 LUCIEN ROUSSEAU.Canada \u2014 Province of Quebec District of Trois-Rivières IL Paul Chevalier Inc.Notice is hereby given that \"IL Paul Chevalier Inc.\", a company incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, April 26th, 1954, has established its head oflice at 552 Mercier Avenue, in the city of Shawinigan Falls, district of Trois-Rivières.Signetl at Shawinigan Falls, this December 15th, 1955.H.P.CHEVALIER, 41446 President.Cana«la \u2014 Province of Quebec District of Trois-Rivières Shawinigan Auto Electric Inc.Notice is hereby given that \"Shawinigan Auto Electric Inc.\", a company incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, December 20th, 1954, has established its head oflice at 794-5th, Street, in the city of Shawinigan Falls, district of Trois-Rivières.Signed at Shawinigan Falls, this December 15th, 1955.RENÉ CLAVET, 41447 President.(A.G.10424-54) Mt-Bruno Construction Inc.Special By-law No.J, \"That the head office of the company, presently situated at 400 Oak Street, St.Lambert, be changed to 1701 Montarville Street, St.Bruno, Quebec.\" True extract.Montreal, August 1st, 1955.LUCIEN ROUSSEAU, 41442-o Secretary.Vente \u2014 Loi de faillite Canada, Province dc Québec, district de Québec, Cour Supérieure, (En matière de Faillite).Dans l'affaire dc la faillite de: Legcn-dre Automobile Inc., corps politique et incorporé ayant sa place «l'affairés à Montmagny, Que.garagistes, débitrice.AVIS DE VENTE Avis est par les présentes donné que: VENDREDI, le TROIS FÉVRIER 1956, à DEUX heures de l'après-midi, sera vendu par encan public, à la porte de l'église de la ville de St-Thomas de Montmagny, Co.Montmagny, l'immeuble ci-après décrit, savoir: Item a) Un terrain situé sur la me St-Étiennc en la ville dc Montmagny, avec le garage y érigé lequel terrain fait partie du lot N° 73 soixante-treize du cadastre officiel pour la ville de Montmagny, de forme irrégulière et borné comme suit: Au nord partie par la rue St-Étienne et Clément Rouleau, M.V.(Ptic N° 73) et mesurant respectivement 51.8 pi.et 33.2 pi., Sale \u2014 Bakrupcy Act Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of Bankruptcy of: Legendre Automobile Inc., a body politic and corporate having its placeo of business at Montmagny, Que.Garage-keepers, debtor.NOTICE OF SALE Notice is hereby given that: FRIDAY, the THIRD day of FEBRUARY 1956, at TWO o'clock in the afternoon, there shall be sold by public auction, at the door of the Church of the town of St.Thomas de Montmagny, Cty.Montmagny, the \u2022immoveable hereinafter described, to wit: Item a) A piece of land situated on St.Etienne street, in the town of Montmagny, with garage erected thereon, which land forms part of lot No.73 seventy-three of the official cadastre for the town of Montmagny, of irregular shape and bounded as follows: To the north, partly St.Etienne street and Clément Rouleau, V.S.(Part No.73) and measuring respectively QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 81st, 1955, Vol.87, No.62 4041 à l'est par partie du lot appartenant à Clément Rouleau, M.V.et partie à la propriété dc Louis-Georges Talbot (lot 74) et mesurant respectivement 30 pi.et 00.0 pi., au sud par les lots Nos 75 et parties du lot 72 appartenant respectivement au Dr.Jean-Marie Couillard, Paul-Henri Lemieux et Roger Boulanger et à l'ouest par le lot N° 71 appartenant à Mlle A.Cloutier et par le lot N 70 et appartenant à Monsieur Joseph Beaudoin.Le tout tel que mentionné à un plan préparé en date du 0 décembre 1955 par Monsieur J.A.Lafleur, arpenteur-géomètre, de la cité dc Québec, et d'un procès-verbal de bornage accompagnant ce dit plan.Cet item sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et autres servitudes qui peuvent exister, (mise à prix $8,000.00).L'acquéreur de cet immeuble devra respecter le bail actuellement existant entre les syndics et le Ministère de la Défense Nationale; lequel bail expirera le 10 septembre 1956 et l'acquéreur aura le droit de percevoir le loyer à compter du premier février 1956.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressaut aux bureaux des syndics soussignés.Cette vente est faire conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code «le Procédure Civile et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Daté à Québec, ce 22 septembre 1955.Les Co-Syndics, JOSEPH MARMETTE & MAURICE BOULANGER.111, Côte de la Montagne, Québec, 71, rue St-Pierre, Québec.4145S-f)2-2-o Vente par licitation Avis est «lonné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Sorel, dans le district dc Richelieu, le 26 novembre 1955, dans une cause portant le N° 13-126 des dossiers de la Cour Supérieure du district dc Richelieu, dans laquelle, Dame Obéline Perron, épouse commune en biens d'Ernest Girouard rentier, demeurant et résidant à St-Roch, district de Richelieu, et ledit Ernest Girouard pour autoriser son épouse aux fins des présentes, sont demandeurs, ordonnant la licitation de l'immeuble désigné comme suit savoir: \"Un terrain situé au village de St-Roch sur Richelieu, borné comme suit: en front la rue St-Nnzairc, en arrière Mme Paul Duhamel, d'un côté Xavier Berthiaume et de l'autre côté Gérard Duhamel; connu ledit immeuble comme faisant partie du lot numéro trois cent quatre-vingt-cinq (P.385) du cadastre de la paroisse de St-Roch sur Richelieu avec les bâtisses y érigée.\" L'immeuble ci-dessus désigné sera mis en vente à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur le VINGT JAN\\ 1ER 1956 à ONZE heures de l'avant-midi au bureau du protonotaire au Palais «le Justice, à Sorel, sujet aux charges, clauses et comlitions indiqués dans le cahier des charges déposé au Greffe du Protonotaire «le ladite Cour; et que toute opposition afin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation, devra être déposé au Greffe du protonolaire de ladite Cour au 51.8 ft.and 33.2 feet easterly by part of that lot belonging to Clément Rouleau, V.S.ami partly by th property of Louis Georges Talbot (lot 74) ami measuring respectively 36 feet and 00.6 feet, southerly by lots No.75 ami parts of lot 72 belonging respectively to Dr.Jean Marie Couillard, Paul Henri Lemieux and Roger Boulanger, ami westerly by lot No.71 belonging to Miss A.Cloutier and by lot No.70 belonging to Mr.Joseph Beaudoin.All of which as mentioned in a plan prepared December 6, 1955 by Mr.J.A.Lafleur, land surveyor, of the City of Quebec, and certificate of boundary survey accompanying said plan.This item shall be offerc«l for sale to the highest and last bidder subject to rents and other servitudes which may be attaching thereto, (upset price 83,000.00).The purchaser of said immoveable shall respect the lease actually in force between the trustees ami the Department of National Defence; which lease shall expire September 16, 1956 and the purchaser shall have the right to collect the rent as from February 1, 1956.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the offices of the undersigned trustees.This sale is made in accordance with articles 710.717 and 719A of the Code of Civil Procedure and section 55 of the Bankruptcy Act of 1949.This sale is equivalent to a sale made by Sheriff.Conditions of payment: cash.Dated at Quebec, this September 22, 1955.JOSEPH MARMETTE & MAURICE BOULANGER, Joint Trustees.Ill Mountain Hill, Quebec, 71, St.Peter street, Quebec.41458-52-2 Sale by Licitation Notice is given that in vertue of a judgment of the Superior Court, sitting at Sorel, in the district of Richelieu, on novembcr 26, 1955, in a case bearing No.13-126 of the records of the Superior Court for the district of Richelieu, wherein Dame Obéline Perron, spouse in community of goods with Ernest Girouard, fund-holder, living at St-Roch, district of Richelieu, and the said Ernest Girouard to authorize his wife, ordering the licitation of immovable described as follows, to wit: \"A property situated at the village of St-Roch sur Richelieu limited as follows: in front the St-Nazaire St., in back Mrs Paul Duhamel, in one side M.Xavier Berthiaume and in the other side M.Gérard Duhamel; know and designate as a part of lot number three hundred eighty-five (P.385) on the official plan and in the book of reference for the parish of St-Roch sur Richelieu with over builders.\" The above described immovable will be sold by auction and ajudged to the highest and last bidder on the TWENTIETH day of JANUARY 1956.at ELEVEN o'clock in the forenoon, at the office of the Prothonotary, in the Court House at Sorel, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges file«l in the office of the Prothonotary of the said Court; and any opposition to annul, to secure charges of the withdray to be made to the said licitation, must be filled in the office of the pro- 4042 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 1965, Tome 87, N° 52 moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition afin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit dc le faire.Sorel, le 9 décembre 1955.Le Procureur des demandeurs, 41377-50-2-o PAUL EMILE ALLY.thonotary of the said Court, as least twelve day before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within the six days following the adjudication; and, failing the parties to file the said oppositions within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Sorel, December 9th, 1955.PAUL ÊMILE ALLY, 41377-50-2-o Attorney for the plaintiffs.Vente pour taxes Sale for Taxes Province de Québec \u2014 District dc Roberval Municipalité de canton Delisle Avis public est, par les présentes, doiuié que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du 12 décembre 1955, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi dc la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, c.207), de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arriérés de taxes dues à la corporation municipale dc canton Delisle, avec intérêt et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle publique de Snint-Cœur-de-Marie, MERCREDI, le DIX-HUIT JANVIER 1956, à DIX heures et TRENTE dc l'avant-midi.Toutefois, seront exclus dc la vente les immeubles sur lesquels les taxes devenues exigibles le ou avant le 31 décembre 1955,.auront été payées avant le moment de la vente.1° Georges Potvin.\u2014 La demie est du lot N° 27 (M E.N° 27) du rang cinq (5), du cadastre officiel du canton Delisle, comté Lac St-Jean, mesurant cinquante acres environ, bornée au nord au rang six, a l'est au lot N° vingt-six, au sud au chemin public, tel que lo tout 80 trouve actuellement avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes.2° Adélard Potvin.\u2014 La juste demie ouest du lot do terre N° 27 (y2 O.20 N° 27), du rang cinq (5).au cadastre officiel du canton Delisle, avec les bâtisses y érigiées, laquelle demie ouest est, ainsi, bornée: au nord, au trait carré des rangs cinq et six dudit canton; au sud, au chemin do front dos rangs quatre et cinq du môme canton; à l'est, à la juste demie est du lot, dont elle fait partie, et appartenant à Georges Potvin; et à l'ouest, au lot vingt-huit (N° 28).3° Succession Onésimo Martel.\u2014 Une lisière do terrain de forme irrégulière et située dans la municipalité de Delisle, prise à même le lot N° deux (2), du rang doux, au cadastre officiel du canton Delisle.Cette lisière de terrain traverse, en diagonale, le lot N° deux, du rang deux et est décrite comme suit: Commençant à l'intersection de la ligne de division des lots un et deux, d'avec la ligne centrale de la voie ferréo au chaînage 700-38, de liî on suivant ladite ligne oentralo de la voie ferrée dans une direction nord-ouest, une distance de mille trois cent quatre-vingt-sept pieds (1,387').jusqu'à son intersection avec la ligne de division des lots 2 et 2 au chaînage sept cent quatorze vingt-cinq, avec une largeur uniformo de deux cents pieds, deux cents pieds (200') au nord-est et cent pieds (100') au sud-ouest, mesurée perpendiculairement avec la ligne centrale de la voie ferrée.Cette lisière do terrain contient une suporficio de trois acres et quatre dixièmes 3.4, plus ou moins, mesure anglaise.Ce terrain est borné comme suit: au nord-est ot au sud-ouest, par lo résidu du lot N° 2; à l'est par lo lot N° 1; à l'ouest par lo lot N-P.3-4 ot par lo lot P.3, appartenant à Ernest Harvey ou représentants.4° Henri Larouche.\u2014 a) Un emplacement sis, et situé au front sud-est du lot N° 31 des plan et livre de renvoi officiels du cadastre fait pour le cinquième rang du canton Delisle, mesurant 100 pieds de profondeur sur une largeur de 60.Borné à l'ouest et au nord, par le reste du lot 31 dont il fait partie; à l'est par le terrain do Jos.Simard ot au sud par lo chemin de front.b) Un lopin de torro faisant partie du lot 30, du rang Province of Quebec \u2014 District of Roberval Municipality of the township of Delisle Public notice is hereby given that the Municipal Commission of Quebec, by a decree dated December 12, 1955, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, c.207), to sell the immoveables hcreinunder designated to meet the payment of taxation arrears due the Municipal Corporation of the township of Delisle, with interest and costs, and that consequently, the said immoveables shall be sold at public auction in the public hall of St.Coeur-de-Marie, WEDNESDAY, the EIGHTEENTH day of JANUARY, 1956, at TEN THIRTY in the forenoon.However, there shall be excluded from the sale, the immoveables on which the taxes exigible on or before the 31 of December 1955, shall have been paid at the time of the sale.1.Georges Potvin.\u2014 The easterly half of lot No.27 (H E.No.27), range five (5), of the official cadastre of the township of Delisle, county of Lake St.John, measuring some fifty acres, bounded northerly by range six, easterly by lot No.twenty-six, southerly by the public highway, all of which as it actualy stands with servitudes both active and passive, apparent and unapparent.2.Adélard Potvin.\u2014 The exact westerly half of lot of land No.27 (14 W.20 No.27), range five (5).of the official cadastre for the township of Delisle, with buildings erected thereon, which westerly half is thus bounded: northerly by the range line of ranges five and six of said township; southerly, by the front road of ranges four and five of the samo township; eastorly, by the exact easterly half of the lot, of which it forms Eart, and belonging to Georges Potvin; and westerly, y lot twenty-eight (No.28).3.Estate Onésime Martel.\u2014 A strip of land of irregular shape and situated in the municipality of Delisle, taken from said lot No.two (2) range two, of the official cadastre of the township of Delisle, Said strip of land crossing diagonally lot No.two, range two and is described as follows: Commencing at the intersection of the dividing line of lots one and two, between the central line of the railroad at ohaining 700-38, thence along the said railroad central line in a northwesterly direction, a distance of one thousand three hundred and eighty-seven feet (1,3870 as far as its intersection with the dividing line of lots 2 and 2 at chaining seven hundred and fourteen twenty-five, with a uniform width of two hundred feet, two hundred feet (200') northeast and one hundred feet (1000 to the southwest, measured perpendicularly with the railroad central line.This strip of land contains an area of throe acres and four tenths 3.4, more or less, English moasuro.The said land is bounded as follows: northeasterly and southwesterly, by the residue of lot No.2; easterly by lot No.1 ; westerly by lot N-P 3-4 and by lot P.3, belonging to Ernest Harvey or representatives.4.Henri Larouohe.\u2014 a) An emplacement, lying and situated to the southeast front of lot No.31 of the official plan and book of reference of the cadastre for range five of the township of Delisle, measuring 100 feet in depth by a width of 50.Bounded westerly and northerly, by the residue of lot 31 of which it forms part; easterly by the land of Jos.Simard and southerly by the front road.b) A plot of land forming part of lot 30, range 5, of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 31st, 1955, Vol.87, No.52 4043 5, du cadastre officiel do canton Delisle, tel que clôturé et occupé; borné au nord et à l'est par le reste du lot 30; à l'ouest par lo lot N° 31; au sud par le chemin public, mesurant 50 pieds de largeur par 100 pieds de profondeur, avec toutes les servitudes actives et passives, attachées audit immeuble.5° Edmond Bouchard.\u2014 Un terrain ou emplacement, situé en la paroisse de St-Cœur-do-Marie, mesurant une demie-acre (H acre) de largeur, de l'est à l'ouest, sur un acre (1 acre) do profondeur, du nord au sud, faisant partie du lot numéro trente-sept (37), du rang cinq (5) aux plan et livre do renvoi officiels du cadastre de canton Delisle, Borné au sud, au chemin dc front des rangs quatre et cinq dudit canton; à l'est, au lot numéro trente-six, appartenant à John Larouche, et des autres côtés au reste du lot dont il fait partie et appartenant à Anicet Bouchard, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, sauf à distraire la servitude concédée â la Cie Électrique du Saguenay.Le prix d'adjudication dc chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera, en outre, sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Saint-Cœur-de-Maric, le 16 décembre 1955.Le Secrétaire-trésorier, 41413-51-2-0 NOËL DUFOUR.VENTES PAR SHERIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnéa ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province dc Québec District dc Beauharnois Cour Supérieure, / T_TODGE BROS.LTD., un N° 376,976 \\ - corps politique et incor-\\ poré.dûment constitué en corporation en vertu de la Loi, et ayant son siège social et principale place d'affaires en les cité et district de Montréal, demanderesse, vs GILLES MORIN, de Châteauguay, district de Beauharnois, défendeur.Comme appartenant au défendeur: Un septième indivisé d'un emplacement situé sur la rue Vinet, en la cité de Châteauguay connu et désigné comme étant le numéro six de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent quatre-vingt-huit (N° 288-6) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joachim de Châteauguay, comté de Châteauguay, mesurant cinquante pieds de longueur par deux cent quatre-vingt-cinq pieds de profondeur dans la ligne à l'est et trois cent quinze pieds de profondeur dans la ligne à l'ouest, avec bâtisses dessus érigées.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de N.D.de l'Assomption de Châteauguay Station, comté de Châteauguay, le JEUDI, NEUF FÉVRIER 1956, à DIX heures de l'avant-midi.\u2022 Le Shérif, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.Salaberry de Valley field, le 20 décembre 1955.41463-52-2 GASPÉ Fieri Facias de Terris District de Rimouski Cour de Magistrat, / TJTARRY BÉLANGER N° 31347.«j il de Sayabec, P.Q.de-{ mandeur; contre PHJLIP- the officiai cadastre of the township of Delisle, such as it is fenced-in and occupied, bounded northerly and easterly by the residue of lot .'0; westerly by lot No.31 ; southerly by the public highway, measuring 50 feet in width by 100 feet in depth, with all servitudes both active and passive, attaching to said immoveable.5.Edmond Bouchard.\u2014 A piece of land or emplacement situated in the parish of St.Cœur-de-Marie, measuring a half acre (^ acre) in width,'from east to west, by one acre (1 acre) in depth, from north to south, forming part of lot number thirty-seven (37), range five (5) on the official plan and book of reference of the cadastre of the township of Delislo.Bounded to the south, by the front road of ranges four and five of said township; easterly, by lot number 36, belonging to John Larouche, and on the other sides by the residue of the lot of which it forms part and belonging to Anicet Bouchard, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies, save and except the servitude granted to the Saguonay Electric Company.The purchasing price of each one of said immoveables shall be payable immediately.However, the sale shall be subject to a right of redemption and to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at St.Cœur-dc-Maric, December 16, 1955.NOËL DUFOUR, 41413-51-2 Secretary-Treasurer.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province of Quebec District of Beauharnois Superior Court, TTLTÔDGE BROS.LTD., a No.376,976 < A *¦ body politic and cor-v poratc, duly incorporated according to law, and having its head office and principal place of business in the city and district of Montreal, plaintiffs, vs GILLES MORIN of Châteauguay, in the district of Beauharnois, defendant.As belonging to the defendant: An undivided one-seventh of an emplacement, situated on Vinet Street, jn the city of Châteauguay, known and designated as number six of the the official subdivision of the original lot number two hundred and eighty-eight (No.288-6) of the Official Plan and Book of reference of the parish of St.Joachim de Châteauguay, county of Châteauguay, measuring fifty feet long, by two hundred and eighty-five feet in depth, in the line to the east, and three hundred and fifteen feet in depth, in the line to the west, with buildings thereon erected.To be sold at the parochial church door of N.D.de l'Assomption of Châteauguay Station, county of Châteauguay, THURSDAY the NINTH day of FEBRUARY, 1956, at TEN o'clock in the forenoon.ERNEST POIRIER.Sheriff's Office, Sheriff.Salaberry de Valleyfield, December 20th, 1955.41463-52-2 GASPÉ Fieri Facias de Tern's District of Rimouski Magistrate's Court, ( T-JARRY BÉLANGER, No.31347.< 1a 0f Savabec, P.Q., I Plaintiff vs PHILIPPE 4044 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 81 décembre 1955, Tome 87, N° 52 PE GENDRON de St-Octave
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.