Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 mai 1956, samedi 5 (no 18)
[" Tome 88, N° 18 1563 Vol.88, No.18 \"7 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC , Québec, samedi 5 mai 1956 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlement h 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, May 5th, 1956 \u2014i NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one.language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended wifhout further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final dek Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Qffice, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.' rit 1564 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1956, Tome 88, N* 18 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième, à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration, m 8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502-1-52 Lettres patentes (P.G.10552-56) .Aimé Boileau Ltée i Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre février 1956, constituant en corporation: Aimé Boileau, fils, Jean Chartrand, entrepreneurs, et Madame Lucille L'Heureux Boileau, ménagère, épouse contractueflement séparée de biens dudit Aimé Boileau, fils, tous de Ville Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Aimé Boileau Ltée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-0 P.FRENETTE.Letters Patent (A.G.10552-56) Aimé Boileau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February 1956, incorporating: Aimé Boileau, junior, Jean Chartrand, contractors, and Mrs.Lucille L'Heureux Boileau, housewife, wife contractually separate as to property of the said Aimé Boileau, junior, all of the town of Saint Laurent, judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a construction company, under the name of \"Aimé Boileau Ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at the town of Saint Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of February 1956.P.FRENETTE, 42313 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.88, No.18 1565 (P.G.10565-56) A mar Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf février 1956, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, Cyril E.Schwis-berg, avocats et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à mettre sur le marché, fournir et distribuer et négocier de l'essence, huiles, pétrole et sous-produits, sous le nom de \"Amar Enterprises Inc.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3315 est, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf février 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313 P.FRENETTE.(P.G.10741-56) Association des Loisirs de Ste-Foy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix mars 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Gilbert Beaulieu, gérant, Benoit Lachance, prêtre, vicaire, Emile Boiteau, notaire, Gérard Rény, Roland Nolet, fonctionnaires, N.-A.Founder, industriel, Arthur Fréchet, conseiller d'orientation, Jean Dubuc, évaluateur, de Sainte-Foy, et Jacques L'Heureux, avocat, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Travailler au bien-être physique ou/et moral des enfants, jeunes gens et jeunes filles de la municipalité de Sainte-Foy, sous le nom de \"Association des Loisirs de Ste-Foy Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-0 P.FRENETTE.(P.G.47875-53) Christ College and Seminary Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre février 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Harold George Martin, D.Th., D.Ph., D.D., ministre du culte, Virginia Eloise Dorsey, M.A., D.Litt.professeur & éditrice, épouse séparée de biens dudit Harold George Martin et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de Vau-dreuil, Sydney Comber, architecte, de Montréal, tous trois du district judiciaire de Montréal, Joseph Henry Wagnell et Henry Judson Davis, D.Th., D.D., tous deux ministres du culte, de \"Wildwood\" Hornell, État de New-York, E.U.A., pour les objets suivants: (A.G.10565-56) Amar Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of February, 1956, incorporating: Samuel Greenblatt, Cyril E.Schwisberg, advocates, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of marketers, suppliers and distributors of and traders in gasoline, oils, petroleum, products and by-products, under the name of \"Amar Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at 3315 Sherbrooke St.East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of February, 1956.P.FRENETTE, 42313-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10741-56) Association des Loisirs de Ste-Foy Inc.Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of March 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Gilbert Beaulieu, manager, Benoit Lachance, priest, vicar, Emile Boiteau, notary, Gérard Rémy, Roland Nolet, civil servants, N.-A.Fournier, industrialist, Arthur Fréchet, vocational adviser, Jean Dubuc, appraiser, of St.Foy, and Jacques L'Heureux, advocate, of Quebec, all of the judicial district of Quegec, for the following purposes: Further the physical or/and moral welfare of children, youths and young girls of the municipality of Saint Foy, under the name of \"Association des Loisirs de Ste-Foy Inc.\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of tho corporation will be at Saint Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of March 1956.P.FRENETTE, 42313 Acting Deputy Attorney General.(A.G.47875-53) Christ College and Seminary Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of February, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Harold George Martin, Th.D., Ph.D.D.D., clergyman, Virginia Eloise Dorsey, M.A., Litt.D.teacher & editor, wife separate as to property of the said Harold George Martin, and duly authorized by him to these presents, both of Vaudreuil, Sydney Comber, architect, of Montreal, all three of the judicial district of Montreal, Joseph Henry Wagnell and Henry Judson Davis, Th.D., D.D., both clergymen, of \"Wildwood\" Hornell, State of New York, U.S.A., for the following purposes : 1566 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1956, Tome 88, N° 18 Établir etfmaintenir un collège concentre sur le Christ et un séminaire théologique, sous le nom de \"Christ College and Seminary\".Le; montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 81,000,000.Le siège social de la corporation sera à \"Wildwood\" Vaudreuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre février 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313 P.FRENETTE.(P.G.10569-56) Donegal Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du.vingt-cinq février 1956, constituant en corporation: Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, Maurice Johnson, avocat et Yvette Marcoux, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme agents d'immeubles et courtiers, sous le nom de \"Donegal Ltd.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq février 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313 P.FRENETTE.(P.G.10593-56) Gagnon Frères (Verdun) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit février 1950, constituant en corporation: Raymond Gagnon, Y van Blackburn et Dollard Blackburn, tous marchands, des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, machines agricoles, accessoires électriques et nouveautés, le bois et autres matériaux et leurs produits, sous le nom de \"Gagnon Frères (Verdun) Ltée\", avec un capital total de S10.000, divisé en 1,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5035, avenue Verdun, Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit février 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-o P.FRENETTE.(P.G.10498-56) Gay Town Sports Wear Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux février 1956, constituant en corporation: Neil Phillips, Melvin Rothman, tous deux avocats, de la cité de Westmount, Yvonne Bélanger et Sylvia Vineberg, secrétaires, filles To establish and maintain a Christ centered college and theological seminary, under the name of \"Christ College and Seminary\".The amount to which the value of the immoveable, property to which the corporation may possess, is to be limited, is SI,000,000.The head office of the corporation will be at \u2022¦ \"Wildwood\" Vaudreuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of February, 1950.P.FRENETTE, 42313-Q Acting Deputy Attorney General.(A.G.10569-56) Donegal Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the the twenty-fifth day of February, 1956, incorporating: Gérard Corbeil, lawyer, of Longueuil, Maurice Johnson, lawyer, and Yvette Marcoux, secretary, spinster, of Montreal, all of the judicia Idis-trict of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate agent and broker, under the name of \"Donegal Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.\"The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of February, 1956.P.FRENETTE, 42313-0 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.10593-56) Gagnon Frbres (Verdun) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eithth day of February, 1956, incorporating: Raymond Gagnon, Yvan Blackburn and Dollard Blackburn, all merchants, of the city and judicial district of Chicoutimi, pfor the following purposes: To manufacture and carry on a business dealing in immoveables, farm implements, electrical accessories and novelties, wood and other materials and their products, under the name of \"Gagnon Frères (Verdun) Ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 5035 Verdun Avenue, Verdun, district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of February, 1956.P.FRENETTE, 42313 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10498-50) Gay Town Sports Wear Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of February, 1956, incorporating: Neil Phillips, Melvin Rothman, both advocates, of the city of Westmount, Yvonne Bélanger and Sylvia Vineberg, secretaries, filles majeures, of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.88, No.18 1567 majeures, de Montreal, tous du district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements pour sport et articles vestimentaires pour enfants et adolescents, sous le nom de \"Gay Town Sports Wear Co.Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 510 rue McGill, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux février 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313 P.FRENETTE.(P.G.10575-56) Hercule Jasmin & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première, partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq février 1956, constituant en corporation: Hercule Jasmin, Bernard Jasmin, courtiers d'assurance, et Gertrude Deslauricrs Jasmin, ménagère, épouse contractuellcment séparée de biens de Hercule Jasmin, tous de Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerces de courtiers et agents d'assurance et d'immeubles, sous le nom de \"Hercule Jasmin & Fils Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq février 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-0 P.FRENETTE.(P.G.10921-56) Ludovic Doré, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mars 1956, constituant en corporation: Ludovic Doré, garagiste, Adrien Doré, mécanicien, et Jacques Déry, comptable, tous de Neuville, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles, machines aratoires, leurs parties et accessoires; faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Ludovic Doré, Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 300 actions privil4giées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Neuville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-o P.FRENETTE.(P.G.10563-56) m.Joseph Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-sept février 1956, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, Cyril E.Schwis- Montreal.all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sportswear, and children's and teenagers wearing apparel, under the name of \"Gay Town Sports Wear Co.Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 510 McGill Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of February, 1950.P.FRENETTE, 42313-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10575-50) Hercule Jasmin & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of February, 1056, incorporating: Hercule Jasmin, Bernard Jasmin, insurance brokers, and Gertrude Deslauricrs Jasmin, housewife, wife contractually separate as to property of Hercule Jasmin, all of Saint-Laurent, judicial district of Montreal, for the following purposes: Of operating as brokers and agents in insurance and real estate, under the name of \"Hercule Jasmin & Fils Ltée\", with a total capital stock of S40,000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company will be at Ville Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of Februarv, 1956.P.FRENETTE, 42313 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10921-56) Ludovic Doré, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second clay of March, 1956, incorporating: Ludovic Doré, garage-keeper, Adrien Doré, mechanic, and Jacques Déry, accountant, all of Neuville, judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on a business dealing in motor vehicles, farm implements, their spare parts and accessories; to carry on business as garage-keepers, under the name of \"Ludovic Doré, Inc.\", with a total capital stock of S60.000, divided into 300 common shares of a par value of S100 each and into 300 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Neuville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of March, 1956.P.FRENETTE, 42313 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10563-56) m.Joseph Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of February, 1956, incorporating: Samuel Greenblatt, Cyril E.Sohwisberg, advo- 1568 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1956, Tome 88, N° 18 berg, avocats et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de propriétés immobilières, sous le nom de \"M.Joseph Realties Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 160 est, rue Ontario, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept février 1956.t -L'Assistant-procureur général suppléant, 42313 P.FRENETTE.(P.G.10578-50) Midvidy Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept février 1950, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch et Abraham Shuster, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de portefeuille eC de placements, sous le nom de \"Midvidy Investment Corporation\", avec un capital-actions divisé en 200 actions ordinaires sans valeur au pair et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept février 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313 P.FRENETTE.(P.G.10612-56) Nadeau & Du mont Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies _.____ tion of wheat, meat and \"supplement\" raastîç$TCL .\" or any employee in charge of the mixers/; .,\\vjVV J^f the Provincial Secretary, this twenty-fourth day of April.1956.JEAN BRUCHÉSI, 42323 Under Secretary of the Province.(A.G.14333-53) Copper Cliff Consolidated Mining Corporation (No Personal Liability) Special By-law \"F\" \"Be it enacted anil it is hereby enacted (subject to the approval of the shareholders) as a spécial by-law of Copper Cliff Consolidated Mining Corporation as follows: 1.The number of Directors of the Company be ami the same is hereby increased from five to seven.2.Four Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.The first paragraph of By-law No.2 is replaced by the following: \"The affairs of the Company shall be managed by a Board of seven Directors, four of whom shall form a quorum.\" Certified true copy.(Seal) (Sgd.) JOHN McG.HOME, 42348-0 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1966, Vol.88, No.18 1595 Avis de rachat partiel Cite de Rouyn (Comté de Témiscamingue) Émission de $145,000 à 3^%, portant la date du 1er juillet 1950 et échéant en séries jusqu'au 1er juillet 1960 (règlement d'emprunt No.291).Avis public est par les présentes donné que la cité de Rouyn, comté de Témiscamingue, rachètera par anticipation, au pair, le 1er juillet 1950, en vertu d'une clause de rachat insérée dans ledit règlement N° 291, et reproduite sur les obligations, les obligations suivantes de l'émission ci-dessus désignée: 1er juillet 1900 \u2014 $91,000.Lesdites obligations deviendront dues et payables et elles seront payables et rachetées, principal et intérêt, à la date ci-dessus mentionnée, en monnaie légale du Canada, avec intérêt couru jusqu'au 1er juillet 1956, sur présentation et remise d'icelles, avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 1er juillet 1956, à toutes les succursales de la Banque Canadienne de Commerce dans la province de Québec.Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er juillet 1956.Donné à Rouyn, comté de Témiscamingue, ce 23 avril 1956.Le Secrétaire-trésorier, 42325-0 ROGER ST-SAUVEUR.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Employés de la Crémerie Crête Inc., de Grand'Mère\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la province le vingt et un avril 1956.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Grand-Mère, district judiciaire des Trois-Rivières.Le Sous-secrétaire de la province, 42332-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \".L'Association des Employés du Papier Ciré de Ville Mont-Royal\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée le cinq avril 1956.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, 42333-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.11327-55) Les Entreprises Boileau Inc.Règlement N° III réduisant le nombre des directeurs de quatre à trois: Directeurs: 1° Nombre.Les affaires de la compagnie seront administrées par un conseil d'administration composé de trois membres.Vraie copie.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 42339-o PAUL BASTIEN.Notice of partial redemption City of Rouyn (County of Témiscamingue) An issue of $145,000 at 3%%, bearing date of July 1st, 1950 and maturing serially up to July 1st, 1960 (loan by-law No.291).Public notice is hereby given that the city of Rouyn, county of Témiscamingue, shall redeem in advance, at par, on July 1st, 1956, by virtue of a redemption clause inserted in said by-law No.291, and reproduced on the bonds, the following bonds of the issue mentioned hereinabove: July 1st, 1960 \u2014$91,000.The said bonds shall become due and payable and shall be paid and redeemed, both principal and interest, on the dated mentioned hereinabove, in legal currency of Canada, with accrued interest up to July 1st, 1956, upon presentation and surrender of same, together with all interest coupons maturing after July 1st, 1956, at all branches of the Canadian Bank of Commerce, in the Province of Quebec.The said bonds shall cease to bear interest as from July 1st., 1956.Given at Rouyn, county of Témiscamingue, this April 23, 1956.ROGER ST-SAUVEUR, 42325 Secretary-Treasurer.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Employés de la Crémerie Crête Inc., de Grand'Mère\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on the twenty«-first day of April 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is at Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières.JEAN BRUCHÉSI, 42332 Under Secretary of thé Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Employés du Papier Ciré de Ville Mont-Royal\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized on April fifth, 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI, 42333 Under Secretary of the Province.(A.G.11327-55) Les Entreprises Boileau Inc.By-law No.Ill decreasing the number of directors from four to three.Directors: 1.Number.The affairs of the company shall be managed by a Board of Directors composed of three members.True copy.(Seal) PAUL BASTIEN, 42339 Secretary-Treasurer. 1596 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 5 mai 1956, Tome 88, N° 18 AVIS (I/oi des syndicats professionnels) ]m formation d'une société, sous le nom de \"L'Union Indépendante des Employés Manuels de la cité de Dorval\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de.la Province, le trente avril 1956.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Dorval, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire dc la province.42340-o JEAN BRUCHÉSI.Avis tie rachat partie] Les commissaires d'Écoles pour la municipalité de Saint-.Iean-Poict-Joli (Comté dc L'Islet) Émission de S 105,000 d'obligations à 3-33^-4%, portant la date du 1er juillet 1955 et échéant en série jusqu'au 1er juillet 1975 (résolution d'emprunt en date du 15 mai 1955).Avis public est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Jcan-Port-.Ioli, comté de L'Islet, rachèteront par anticipation, au pair, le 1er juillet 1950, en vertu d'une clause de rachat insérée dans ladite résolution d'emprunt et reproduite sur les obligations, les obligations suivantes: 4 x .?1,000 Nos 88, 89, 90 et 91 de l'année 1975.Lesdites obligations deviendront dues et payables et elles seront payables et rachetées, principal et intérêt, à la date ci-dessus mentionnée, en monnaie légale du Canada, avec intérêt couru jusqu'au 1er juillet 1956, sur présentation et remise d'icclles, avec tous les coupons «l'intérêt échéant après le 1er juillet 1956 attachés, au bureau de la Banque Provinciale du Canada à Montréal, a Québec ou à St-Jcan-Port-Joli, au choix du détenteur.Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er juillet 1956.Donné à St-Jcan-Port-Joli, comté de L'Islet, ce 1er mai 1956.Le Secrétaire-trésorier, 42311-o PATRICE CARON.Extrait d'une assemblée du bureau dc direction de Master T.V.and Furnituhe Co.Ltd.Règlement N° 24 étant un règlement se rapportant à la distribution de l'actif de Master T.V.and Furniture Co.Ltd.Attendu que la compagnie a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires.Attendu que la compagnie n'a pas de dettes ou obligations.En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de Master T.V.and Furniture Co.Ltd.que : 1° La compagnie soit et elles est, par les présentes, autorisée à disposer de ses biens, distribuer son actif au pro rata entre ses actionnaires et procéder subséquemment à sa dissolution par voie de procédures d'abandon de charte, conformément à l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Union Indépendante des Employés Manuels de la cité de Dorval\".for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary, on the thirtieth day of April, 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is at Dorval, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI, 42340 Under Secretary of the Province.Notice of partial redemption Tiik School Commissioners for the Municipality ok Saint-Jean-Port-Joli (( 'ounty of L'Islet) An issue of S105.000 at 3-3)^-4%, under date of July 1st., 1955 and maturing serially up to July 1st.1975 (Loan resolution dated May 15.1955.) Public notice is hereby given that the School Commissioners for the municipality of St-Jean-Porl-Joli, county of L'Islet, shall redeem in advance, at par, on July 1st., 1956, by virtue of a redemption clause inserted in said resolution ami reproduced on the bonds, the following bonds of the said issue: 4 x S 1.000 Nos.88, 89, 90 and 91 of the year 1975.The said bonds shall become due and payable and shall be paid and redeemed, both principal and interest, on the date mentioned hereinabove, in legal currency of Canada, with accrued interest up to July 1st., 1950, upon presentation and surrender of same, together with all interest coupons maturing after July 1st., 1950, attached thereto, at the office of the Provincial Bank of Canada, at Montreal, Quebec or St-Jean-Port-Joli, at the holder's choice.The said bonds shall cease to bear interest as from July 1st., 1950.Given at St-Jean-Port-Joli, county of LTslet, this May 1st.1950.PATRICE CARON, 42341 Secretary-Treasurer.Extract of a meeting of the board of directors o^ Master T.V.and Furniture Co.Ltd.By-law No.24 being a By-law respecting the distribution of the assets of Master T.V.and Furniture Co.Ltd.Whereas the Company has ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs; Whereas the Company has no debts or obligations; Therefore be it enacted as a By-law of Master T.V.and Furniture Co.Ltd.that: 1.The Company be and is hereby authorized to dispose of its property, distribute its assets rateably among its shareholders and subsequently to proceed to disolution by way of Surrender of ('barter proceeding under Section 20 of the Quebec Companies' Act. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1956, Vol 88, No.18 1597 2° Les directeurs et officiers sont, par les présentes, autorisés et dirigés à faire, signer et exécuter toutes choses, actes et documents nécessaires ou désirables à l'entière exécution du précédent.Décrété ce 23e jour d'avril 1956.Le Président, ISRAËL ZIMMERMAN.Le Secrétaire, LUCIA ZIMMERMAN.Je, Lucia Zimmerman, secrétaire de Master T.V.and Furniture Co.Ltd., certifie, par les présentes, que le précédent est une copie véritable et conforme du règlement N° 24 de la compagnie, passé à une assemblée du bureau dc direction tenue à Montréal, le 23 avril 1956 et confirmé à une assemblée spéciale des actionnaires tenue à Montréal, le 23 avril 1956.(Sceau) Le Secrétaire, 42342 L.ZIMMERMAN.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Syndicat National des Employés de la Cité dc St-Laurent Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée le onze avril 1956.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé en la cité dc St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, 42343-o JEAN BRUCHÊSJ.(P.G.8302-53) Vendôme Mines Limited (No Personal Liability) Règlement spécial \"E\" 1.Le nombre des directeurs de cette compagnie est augmenté dc cinq à sept.2.L'article 1 du règlement trois est amendé en rayant le mot \"cinq\" et y substituant le mot \"sept\".Certifié vraie copie: Montréal, P.Q., 23 avril 1050.(Sceau) Le Secrétaire.42351 J.G.BORTEOUS.(P.G.2407-39) Peinture Nationale Limitée National Paint Limited Extrait des Règlements Généraux de la compagnie \"Peinture Nationale Limitée\u2014National Paint Limited\" tels qu'adoptés et ratifiés par les actionnaires dc ladite Compagnie au cours de l'assemblée générale annuelle tenue au bureau de la Compagnie le 17 février 1956, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à cinq : 2° Directeurs: a) Les affaires de la Compagnie seront administrées par un bureau de direction composé de cinq (5) directeurs choisis parmi les détenteurs d'actions ordinaires du capital-actions de la Compagnie.Chaque directeur devra détenir au moins une action ordinaire de la Compagnie, complètement payée.Certifié copie conforme.(Sceau) Le Secrétaire, 42352-0 CHARLES GODBOUT.2.The Directors and Officers are hereby authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.Enacted this 23rd dav of April, 1956.ISRAËL ZIMMERMAN.Prosit lent.LUCIA ZIMMERMAN, Secretary.I, Lucia Zimmerman, she Secretary of Master T.V.and Furniture Co.Ltd., hereby certify that the foregoing is a true ami exact copy of By-law No.24 of the company passed at a meeting of the Board of Directors held at Montreal on April 23rd, 1956, and confirmed at a Special Meeting of the Shareholders hold at Montreal on April 23rd, 1956.(Seal) L.ZIMMERMAN, 42342-o Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Syndicat National des Employés de la Cité de St-Laurent Inc.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on April eleventh, 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is in the city of St-Laurent, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI, 42343 Under Secretary of the Province.(A.G.8302-53) Vendôme Mines Limited (No Personal Liability) Special By-law \"E\" 1.The number of Directors of this Company is increased from five to seven.2.Article 1 of By-law Three is amended by deleting the word \"five\" and substituting therefor the word \"seven\".Certified true copy: Montreal, P.Q., April 23rd, 1950.(Seal) J.G.PORTEOUS, 42351 -o Secretary.(A.G.2407-39) Peinture Nationale Limitée Natknal Paint Limited Excerpt of General By-laws of the company \"Peinture Nationale Limitée \u2014 National Paint Limited\" as adopted and ratified by the shareholders of the said Compa' y during the course of the general annual meeting he'd at the office of the Company on February 17.1950, concerning the increase in the number of its Directors, from three to five: 2.Directors: a) The affairs of the Company shall be administrated by a Board of Directors composed of five (5) Directors chosen amongst the holders of common shares of the capital stick of the Company.Ejich Director shall hold at least one common completely paid-up share of the Company.\" Certified true copy.(Seal) CHARLES GODBOUT, 42352 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1956, Tome 88, N° 18 X G, 10400-56) Avis est donné que.sur la recommandation de !\" Assistant-procureur general.l'Honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 30 avril 1950.les règlements revisés de \"Canadian Pacific Recreation Club (Montreal) Inc.\".conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies vie Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 2e jour vie mai 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 42549 JEAN BRUCHÉSI.(A.G.10400-55) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the revised By-Laws of \"Canadian Pacific Recreation Club (Montreal) Inc.\" were approved by the Honourable the Provincial Secretary on April 30th, 1950, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of May, 1056.LEAN BRUCHÉSI, 42349-o Under-Secretary of the Province.Charte \u2014 Abandon de Avis est, par les présentes, donné epie la compagnie Master T.V.and Furniture Co.Ltd., une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies dc Québec et ayant sou siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 23e jour d'avril 1956.Le Secrétaire.42342 L.ZIMMERMAN.Compagnie autorisées à faire des affaires (Sec.P.200-50) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Calnorth Oils Limited\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province dc Qué-vec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q., 1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera à 132 ouest, rue St-Jacques, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins dc recevoir les assignations dans les procédures prises contre elle, est M.Lovell C.Carroll, C.R., à l'adresse donné ci-dessus.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 1er mai 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 42313-0 JEAN BRUCHÉSI.Charter \u2014 Surrender of Notice is hereby given that Master T.V.and Furniture Co.Ltd., a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 23rd day of April, 1956.Secretary.42342-0 L.ZIMMERMAN.Companie Licensed to do Business (P.Sec.200-50) Notice is hereby given that \"Calnorth Oils Limited\", has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies' Act, R.S.Q., 1941, chapter 279.The principal office of the said Company in the Province is to be at 132 St.James Street, West, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Lovell C.Carroll, Q.C., of the above given address.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of May, 1956.JEAN BRUCHÉSI, 42313 Assistant Provincial Secretary.Compagnies dissoutes (P.G.,12968-54) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par-l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"B.Schaffer & Son Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 novembre 1928.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1956, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-0 P.FRENETTE.(P.G.10121-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre, 276 article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par Companies Dissolved (A.G.12968-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"B.Schaffer & Son Ltd.\", incorporated by letters patent dated November 9, 1928.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1956.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.10121-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attor- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.SS, No.IS 1599 l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Dupresnoy Mines Limited\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 27 mars 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1956, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-o P.FRENETTE.(P.G.12060-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Provureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Greenhill Apts.Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 août 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-o P.FRENETTE.(P.G.12346-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Horticultural Products Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 18 août 1952.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1956, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-o P.FRENETTE.(P.G.10388-50) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon dc la charte dc la compagnie \"Joseph & Company, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 janvier 1928.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42313-o P.FRENETTE.(P.G.12303-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"L.Rajotte et Companie Limitée \u2014 ncy General has been pleased to accept the surrender of the charier of the company \"Dupresnoy Mines Limited\" (No Personal Liability), under the Quebec Mining Companies' Act, incorporated by letters patent dated March 27, 1944.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1956.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.12000-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Greenhill Apts.Inc.\", incoqjorated by letters patent dated August 17, 1945.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1956.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.12346-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Horticultural Products Limited\", incorporated by letters patent dated August eighteenth, 1952.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1950.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.10388-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Joseph & Company, Limited\", incorporated by letters patent dated January 10, 1928.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May.1956.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.12303-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"L.Rajotte et Compagnie Limitée \u2014 L.Rajotte and Company 1000 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 6 mai 1956, Tome 88, N° 1S L.Rajotte and Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 février 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42313-0 P.FRENETTE.(P.O.10694-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Medwer Realties Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 13 décembre 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1956.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42313-0 P.FRENETTE.(P.G.11051-50) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus dc Québec.1941, chapitre 276.article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Real Need of Happiness Toy Shops\", constituée en corporation en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi, par lettres patentes en date du 22 janvier 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 14)56.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42313-0 P.FRENETTE.(P.G.49289-53) Avis est donné qu'en veitu de la première partie dc la Loi des compagnies de Qi.ébec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 27(5, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Ruth Gordon Gowns Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 octobre 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1956, ladite compagnie a été dissoute Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42313-o P.FRENETTE.Limited\", incorporated by letters patent dated February 11, 1949.Notice is also given that from and after April thirtieth.1956.the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1956.P.FRENETTE, 12313 Deputy Attorney General.(A.G.10694-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Medwer Realties Limited\", incorporated by letters patent dated December 13, 1954.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1950.the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1956.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.11051-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Ac\\, the Attorney General his been j leased to accept the surrender of the charter of the company \"Real Need of Happiness Toy Shops\", incorporated under the provisions of Part III of the said Act, by letters patent dated January 22, 1940.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of Mav, 1956.P.FRENETTE, 42313 Deputy Attorney General.(A.G.492S9-53) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Ruth Gordon Gowns Inc.\".incorporated by letters patent dated October 39, 1946.Notice is also given that fr.^m and after April thirtieth, 1956, the said company has been dissvoled.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1956.P.FRENE1TE, 42313 Deputy Attorney General.Département des Affaires municipales Avis est par les présentes donné que, par l'arrêté ministériel numéro 448, du 25 avril 1956, et conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi des cité et villes (S.R.Q., 1941, chapitre 233), il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le règlement N° 596 du conseil Department of Municipal Affairs Notice is hereby given that by Order*in Council number 448, dated April 25, 1956, and pursuant to the provisions of section 43 of the Cities and Towns' Act (R.S.Q.1941, chapter 233), His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to authorize By-law No.596 of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.88, No.18 Kid I municipal de lu filé de Joliette, et de décréter que, à compter de la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement et décrit ci-dessous est détaché de la municipalité du village de Saint-Pierre, comté de Joliette, et annexé à la cité de Joliette.Ce territoire est le suivant: Une certaine étendue de terrain faisant partie des lots 419, 120, 421, 422 et 424 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Paid et dont les limites, en référence au susdit cadastre officiel, sont les suivantes: au nord-est, la limite actuelle de la cité de Joliette s'é'.ablissant par une ligne originant en un point sur le prolongement de la ligne separative des lots 220 et 222 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Charles-Borromée à une distance de cinquante pieds (50.0') au sud-ouest du droit de voie du chemin dc fer National Canadien et traversant les lots 419, 420, 421, 422 et 124 dans une direction perpendiculaire au susdit prolo: gement des lots 220 et 222; au sud-ouest, par une ligue parallèle à la limite nord-est ci-dessus décrite à une distance perpendiculaire de deux cent cinquante pieds (250.0') anglais au sud-ouest d'icelle; au nord-ouest et au sud est respect i veinent les parties «le la ligne nord-oupst du lot 419 et dc la ligne nord-ouest du lot 494 (droit de voie du chemin de fer National Canadien) comprises entre les limites nord-est et sud-ouest ci-dessus décrites; laquelle étendue dc terrain, ensemble avec les chemins, rues, ruelles, cours d'eau ou partie d'iccux à être détachée de la municipalité du village de Saint-Pierre, dans le comté municipal de Joliette.Le Ministre des Affaires municipales, 42314-o YVKS PRÉVOST, C.R.Le soussigné donne avis que.tel (pie demandé par une résolution du 7 septembre 1955 du conseil municipal de la paroisse dc Sainte-Hélène, comté de Bagot, et conformément aux dispositions dc l'article 130 du Code municipal, il a décrété, en date «lu 20 avril 1950.que les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de ladite corporation, sauf celles requises dans la Gazette officielle (le Québec, se feront, à l'avenir, dans la langue française seulement.Le présont avis est publié en vertu de l'article 131 du Code municipal (10 George VI, chapitre 55, section 2).Québec, le 20 avril 1950.Le Ministre des Affaires municipales, 42314-0 YVES PRÉVOST, C.R.Municipal Council of the city of Joliette, and to enact that, as from the date of publication of this notice, the territory mentioned in said bylaw and described hereinunder is detached from the Village Municipality of Saint Pierre, county of Joliette, and annexed to the city of Joliette.The said territory is as follows: A certain piece of land forming part of lots 419, 420, 421, 422 and 424 of the official cadastre of the parish of Saint Paul and the boundaries of which are, with reference to the above official cadastre, the following: northeasterly, the present limits of the city of Joliette, determined by a line originating at a point along the prolongation of the dividing line of lots 220 and 222 of the official cadastre of the parish of Saint-Charlcs-Borromée at a distance of fifty feet (50.0') to the southwest of the right-of-way of the Canadian National Railway and crossing lots 419, 420, 421.122 and 424 in a direction perpendicular to the aforesaid prolongation of lots 220 and 222; southwesterly, by a line parallel to the northeasterly boundary described hereinabove, at a perpendicular distance of two hundred and fifty feet (250.0') English measure, southwesterly thereof; northwesterly and southeasterly respectively those parts of the north-westerly line of lot 419 and the northwesterly line of lot 494 (right-of-way of the Canadian National Railway) included within the northeast and southwest boundaries hereinabove described; which piece of land, together with the roads, streets, lanes, streams or parts thereof to be detached from the Village Municipality of Saint Pierre, in the Municipal county of Joliette.YVES PRÉVOST, Q.C., 42314 \u2022 Minister of Municipal Affairs.The undersigned gives notice that as requested by a resolution under date of September 7, 1955.of the Municipal Council of the parish of Saint Hélène, county of Bagot, and pursuant to the provisions of article 130 of the Municipal Code, he has enacted on April 20, 1950, that publications of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the said corporation, save those required in the Quebec Official Gazette, shall be made, heieaftcr, in the French language only.This notice is published in accordance with article 131 of the Municipal Code (10 George VI.chapter 55, section 2)./ Quebec, April 26, 1950.YVES PRÉVOST.Q.C., 42314 Minister of Municipal Affairs.Département de l'Instruction Publique N° 324-56.Québec, le 25 avril 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus, dans le comté de Beauce, le territoire ci-dessous décrit et de l'annexer à la municipalité scolaire du village de Sacré-Cœur-de-Jésus, dans le même comté.» \"Un lopin de terre situé sur le lot 17 du rang IV du canton de Broughton, dont la largeur est de l]/2 arpents, la profondeur de 13 arpents, borné au nord-ouest par la route N° 1 (route Nationale) au nord-est par monsieur M.Paré, au sud-est par monsieur Lucien Paré et au sud-ouest par le rang VI.\" Le Surintendant de l'Instruction publique, 42291-17-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.324-56.Quebec, April 25, 1956.Application is made to detach from the school municipality of the parish of Sacré-Cœur-de-Jésus, in the county of Beauce, the territory hreinunder described, and to annex it to the school municipality of the village of Sacré-Cœur-de-Jésus, in the same county.\"A strip of land situated upon lot 17 of range IV of the township of Broughton, of which the width is 7^ arrJCnts, the depth of 13 arpents, bounded on the northwest by route No.1 (National highway) on the northeast by Mr.M.Paré, on the southeast, by Mr.Lucien Paré and on the southwest, by range VI.\" 0.J.DÉSAULNIERS, 42291-17-2 Superintendent of Education. 1602 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1956, Tome 88, N° 18 N° 138-50.Québec, le 17 avril 1956.Demande est faite d'ériger en municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire protestante de Matapédia, dans le comté de Bonaven-ture, le territoire des municipalités scolaires de Broadlands, Matapédia, St-Laurent-de-Matapé-dia, Restigouche et Sellarsville, dans le comté de Bonaventure.Le territoire de cette municipalité projetée est décrit comme suit: Canton de Restigouche, (tous les lots inclusivement): lots 1 à 42 du rang I, rivière Restigouche; lots 1 à 21 du rang L, Chemin Kempt; lots 1 à 23 du rang II, Petite Rivière Ouest; lots 7 à 17 du rang II, Rivière Restigouche; lots 1 à 42 du rang I de Matapédia.Canton de Matapédia (tous les lots inclusivement) lots 1 à 14 du rang Rivière Matapédia; 2 à 18 du rang I, Matapédia Sud: lots 1 à 19 du rang I, Rivière Restigouche; lots 1 à 9 des rangs I et II, Matapédia Sud; lots 1 à 9, rang Adams; lots 1 à 5 du rang II, Rivière Matapédia; lots 1 à 9 rang Upsalquitch; lots 1 à 18 du rang Portage.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42269-17-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 147-56.Québec, le 25 avril 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Pointe-Claire, dans le comté de Jacques-Cartier, les lots Nos 110 à 130 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire, pour les annexer à la municipalité scolaire de Pointe-Claireville, môme comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42290-17-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 87-56.Québec, le 25 avril 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Ascot, dans le comté de Sherbrooke, les lots 18 et 19 du rang IV du canton d'Ascot, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire catholique de St-Antoine-de-Lennoxville, môme comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42292-17-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 345-56.Québec, le 25 avril 1956.Demande est faite d'annexer la municipalité scolaire de la paroisse de St-Bruno, dans le comté de Chambly, à celle du village de St-Bruno, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.42293-17-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 361-56.Québec, le 25 avril 1956.Demande est faite d'annexer à la municipalité de Ste-Thérèse-de-Colombier, dans le comté de Saguenay, toutes les parties du canton Betsia-mites, même comté, qui ne sont pas encore organisées au point de vue scolaire, afin qu'à l'avenir cette dite municipalité scolaire comprenne tout cedit canton au complet.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42294-17-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.138-56.Quebec, April 17, 1956.Application is made to erect into a separate school municipality for Protestants only, under the name of \"The Protestant School Municipa-lity of Matapédia, in the county of Bonaventure\" the territory of the school municipalities of Broadlands, Matapédia, St-Laurent-de-Matapé-dia, Restigouche and Sellarsville, in the county of Bonaventure.The territory of this projected municipality is described as follows: Township of Restigouche, (all lots inclusively) : lots 1 to 42 of range I, Restigouche River; lots 1 to 21 of range L, Kempt Road; lots 1 to 23 of range II, \"Petite Rivière\", West; lots 7 to 17 of range II, Restigouche River; lots 1 to 42 of range I of Matapédia.Township of Matapédia (all lots inclusively): lots 1 to 14 of the Matapédia River Range ; 2 to 18 Range I, Matapédia South; lots 1 to 19 of range I, Restigouche River; lots 1 to 9 of ranges I and II, Matapédia South; lots 1 to 9, Adams Range; lots 1 to 5 of Range II, Matapédia River; lots 1 to 9 Upsalquitch Range; lots 1 to 18 of Portage Range.O.J.DÉSAULNIERS, 42269-0 Superintendent of Education.No.147-56.Quebec, April 25, 1956.Application is made to detach from the School Municipality of Pointe Claire, in the county of Jacques Cartier, lots Nos.110 to 136 inclusive of the official cadastre of the parish of Pointe Claire, in order to annex them to the School Municipality of Pointe Claireville, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42290-17-2 Superintendent of Education.No.87-56.Quebec, April 25, 1956.Application is made to detach from the school municipality of Ascot in the county of Sherbrooke, lots 18 and 19 of range IV of the township of Ascot, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the Catholic school municipality of St.Antoine de Lennoxville, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42292-17-2 Superintendent of Education.No.345-56.Quebec, April 25, 1956.Application is made to annex the School Municipality of the parish of St.Bruno, in the county of Chambly, to that of the village of St.Bruno, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42293-17-2 Superintendent of Education.No.361-56.Quebec, April 25, 1956.Application is made to annex to the school municipality of Ste Thérèse-de-Colombier, in the county of Saguenay, all the parts of the Betsia-mites township, same county, which are not as yet organized from the school point of view so that in future, this school municipality will be comprised of the whole of the said township, completely.O.J.DÉSAULNIERS, 42294-17-2 Superintendent, of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.88, No.18 1603 N° 293-50.Québec, le 25 avril 1950.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire du Canton Latour, dans le comté de Saguenay, à la municipalité scolaire de Ste-Thérèse-du-Colombier, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42295-17-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 115-53.Québec, le 30 avril 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire d'Aubert-Gallion, dans le comté de Beauce, les lots 631 à 637 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de St-Georges-Est, pour les annexer à celle de l'Assomption, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42335-18-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 47-56.Québec, le 1er mai 1956.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Ville de St-Germain-de-Rimouski, dans le comté de Rimouski, en celui de Ville de Rimouski, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42336-18-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1434-55.Québec, le 1er mai 1956.Demande est faite de détacher dc la municipalité scolaire de St-Pierre-Baptiste, dans le comté de Mégantic, les lots primitifs 23 à 28 inclusivement des rangs III et IV du cadastre officiel de la paroisse de St-Pierrc-Baptistc, pour les annexer à la municipalité scolaire de Laurier-ville, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42337-18-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1220-54.Québec, le 28 avril 1950.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 2 février 1955, de changer le nom de la municipalité scolaire du village d'Arthabaskaville, dans le comté d'Artha-baska, en celui de \"Ville d'Arthabaska\", même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42338-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 217-56.Québec, le 1er mai 1956.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 25 avril 1956, d'annexer le territoire de la municipalité scolaire de la paroisse de Disraeli, dans le comté de Wolfe, à celui de la municipalité scolaire du village de Disraeli, même comté, soit les lots G, 21 à 43 inclusivement du rang I; 1 à 43 inclusivement du rang II; 1 à 37 inclusivement du rang III; 16 à 43 inclusivement des rangs IV et V, le lot 16 et les lots 32 à 43 inclusivement du rang VI; 14 à 21 inclusivement du rang VII, tous du canton de Garthby; les lots 9 à 19 inclusivement du rang XII; 1 à 10 inclusivement du rang XI; le lot 1 du rang X et les lots A, B, C, D, E, F et 1 à 10 inclusivement du rang III nord-est tous du canton de Stratford.No.293-56.Quebec.April 25, 1956.Application is marie to annex the present territory of the School Municipality of the Township of Latour, in the County of Saguenay, to the School Municipality of St.Thérèse-du-Colombier, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42295-17-2 Superintendent of Education.No.115-53.Quebec, April 30, 1956.Application is made to detach from the school municipality of Aubcrt-Gallion, in the county of Beauce, lots 631 to 637 inclusively, in the official cadastre of the parish of St.Georges-East, to annex them to that of l'Assomption, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42335 Superintendent of Education.No.47-56.Quebec, May 1st., 1956.Application is made to change the name of the School Municipality of the town of St-Gcrmain-de-Rimouski, in the county of Rimouski, to that of the town of Rimouski, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42336-18-2 Superintendent of Education.No.1434-55.Quebec, May 1st., 1956.Application is made to detach from the School Municipality of St-Pierrc-Baptiste, in the county of Megantic, original lots 23 to 28 inclusive of Ranges III and IV of the official cadastre of the parish of St-Pierre-Baptiste, in order that they be annexed to the School Municipality of Laurier-ville, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42337-18-2 Superintendent of Education.No.1220-54.Quebec, April 28, 1956.His Honour, the Lieutenant-Governor in \u2022 Council, by Order in Council, dated February 2nd 1955, has been pleased to change the name of the school municipality of the village of Arthabaskaville, in the county of Arthabaska, into that of \"Town of Arthabaska\", same county.O.J.DÉSAULNIERS, 42338 Superintendent of Education.No.217-56.Quebec, May 1st, 1956.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated April 25, 1956, has been pleased to annex the territory of the school municipality of the parish of Disraeli, in the county of Wolfe hereinunder described, to the school municipality of the village of Disraeli same county.Lots G 21 to 43 inclusively of range I; 1 to 43 inclusive of range II; 1 to 37 inclusively of range III; 16 to 43 inclusively of ranges IV and V, lot 16 and lots 32 to 43 inclusively of range VI; 14 to 21 inclusively of range VII, all of the township of Garthby- Lots 9 to 19 inclusively on range XII; 1 to 10 inclusively of range XI; lot 1 to range X and lots A, B, C, D, E, F and 1 to 10 inclusively of range III northeast, all of the township of Stratford. 1604 GAZETTE OFF (VIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1906, Tome 88, N° 18 Ce changement prendra effet au 1er juillet L956.l.e Surintendant de l'Instruction publique, 1233X-» ().,|.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, (ville de Montréal-Est), division d'enregistrement do Montréal.Avis est par la présentes donné que les lots 92-243 à 92-250, 92-336 à 92-424 ; les lots 02-33S-1.92-338£, 92-345-1, 92-345-2, 92-340-1, 92-346-2, 92-347-1, 92-347-2, 92-348-1, 92-348-2, 92-349-1, 92-349-2, 92-350-1.92-350-2.92-351-1, 92-351-2.92-352-1.92-352-2.92-353-1, 92-353-2, 92-354-1, 92-354-2, 92-3:).\")-1.92-355-2, 92-350-1, 92-356-2, 92-357-1.92-357-2, 92-358-1, 92-358-2, 92-359-1, 92-359-2, 92-360-1, 92-360-2.92-361-1, 92-301-2, 92-302-1.92-362-2, 92-303-1.92-303-2, 92-364-1, 92-364-2, 92-365-1, 92-365-2, 92-3S7-I, 92-387-2, 92-389-1 et 92-389-2 sont annulés en vertu de l'article 217 1A du Code civil.Québec, Il avril 1956.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre.42315-0 A VILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel «le la paroisse de Sainte-Geneviève, division d'enregistrement «le Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 35-1, 35-4 à 35-23, partie du lot 35-2 et les lots 35-24, 35-25 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 avril 1956.Le Département dos Terres et Forêts, Service du Cadastre.Le Sous-ministre.42315-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadast re officiel du village «le Senneterre, division d'enregistrement de I'Abitibi.Avis est par la présente donné que le lot 14 du Bloc 28, une partie des lots 3, 4, 5, 6, 12, 13 et 14 «lu Bloc 22, une partie «les lo's 1.2, 3, 1 et 5 du Bloc 27, une partie des lots 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 10, 17, 18 et 19 du Bloc 28 sont annulés et les lots 19 et 18 du Bloc 22.le lot 22 du Bloc 27 et les lots 21, 22 et 23 du Bloc 28 sont ajoutés en vertu des articles 2174A et 2174 du Code civil.Québec, le 27 décembre 1955.Le Département des Terres et Forets, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 42315-0 AVILA BÉDARD.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION .Conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (S.R.Q.This Order in Council will take effect on July 1st, 1950.O.J.DÉSAULNIERS, 42338 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of Pointe-aux-Trembles, (Town of Montreal East), registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 92-243 to 92-250, 92-330 to 92-424; lots 92-338-1, 92-338-2, 92-345-1, 92-345-2, 92-346-1, 92-340-2, 92-347-1, 92-347-2, 92-34S-1, 92-34S-2, 92-349-1, 92-349-2, 92-350-1.92-350-2.92-351-1, 92-351-2.92-352-1, 92-352-2.92-353-1.92-353-2, 92-354-1, 92-354-2, 92-355-1, 92-355-2.92-350-1, 92-350-2, 92-357-1, 92-357-2, 92-358-1.92-358-2, 92-359-1, 92-359-2, 92-360-1, 92-300-2, 92-301-1, 92-301-2, 92-302-1, 92-302-2, 92-363-1, 92-363-2, 92-304-1, 92-364-2, 92-365-1, 92-305-2, 92-387-1, 92-387-2, 92-389-1 and 92-389-2 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, April, the 11th, 1950.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 42315-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of Sainte-Geneviève, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 35-1, 35-4 to 35-23.part of lot'35-2 ami lots 35-24, 35-25 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec.April the 20th, 1956.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 42315-o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the village of Senneterre, registration division of Abitibi.Notice is hereby given that lot 14 of Block 28, part of lots 3, 4, 5, 6, 12, 13 and 14 of Block 22, part of lots 1, 2, 3, 4 and 5 of Block 27, part of lots 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 10, 17, 18 and 19 of Block 28 are cancelled and lots 19 and 18 of Block 22, lot.22 of Block 27 and lots 21, 22 and 23 of Block 28 are added in virtue of Articles 2174A and 2174 of the civil Code.Quebec, December the 27th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 42315-o Deputy Minister.Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT \u2014 m Pursuant to the procedure established under section 8 of the Collective Agreement Act (R.S.Q. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.88, No.18 1605 1941, chapitre 163 et amendements) l'honorable Antonio Barrette.Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 3088 du 7 août 1940 et amendements, relatif aux métiers dc l'imprimerie dans l'Ile dc Montréal et un rayon de cent (100) milles de ses limites.Que les villes de Shawinigan Falls et Grand' Mère fassent partie de la zone II et que leurs noms soient ajoutés dans la description de ladite zone, apparaissant au paragraphe \"6\" de l'article IL La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date «le publication de cet avis dans la Gazette officielle dc Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère «lu Travail, Québec, le 5 mai 1956.42327-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 103 et amendements), «pie les parties contractantes à la convention collective dc travail relative à l'industrie «le l'automobile dans l'Ile de Montréal, rendu obligatoire par le décret numéro 184 du 8 février 1950, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil les modifications, suivantes audit décret, dans sa teneur modifiée: 1° Les alinéas 3° et 4° du paragraphe \"&\" de l'article IV seront remplacés par les suivants: \"Hommes de service 3.Travail de jour: Soixante (60) heures par semaine sujet aux disposions de l'article X.Définition des homines de service de jour: Les hommes de service de jour sont ceux employés dans un établissement régi par le décret qui travaillent ordinairement et principalement entre sept (7.00) heures du matin et sept (7.00) heures du soir, ou ceux qui, travaillant dans un établissement ayant plus d'une équipe sont affectés au travail de jour, c'est-à-dire, ceux qui font ordinairement leur travail ou la majeure partie d'icelui entre sept (7.00) heures a.m.et sept (7.00) heures p.m.\" \"4.Travail de nuit: Soixante-douze (72) heures par semaine sujet aux dispositions de l'article X.Définition des hommes de service de nuit: Les hommes de service de nuit sont ceux qui, dans le cas d'un établissement ayant plus d'une équipe, font ordinairement leur travail, ou la majeure partie d'icelui durant la nuit, c'est-à-dire entre sept (7.00) heures du soir et sept (7.00) heures du matin, ou encore ceux qui, dans le cas d'un établissement n'ayant qu'une seule équipe, font ordinairement leur travail ou la majeure partie d'icelui entre sept (7.00) heures du soir et sept (7.00) heures du matin.\" 1941, chapter 103 and amendments), the Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that he intemls to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the «lecree No.3088 of August 7, 1940.as amended, relating to the printing trades in the Island of Montreal and a radius of one lnm«lre«l (100) miles from its limits.That the towns of Shawinigan Falls ami Grain!' Mère be included in zone II ami that their names be added in the description of the said zone contained in subsection '&\" of section II.The pyblication of the present notice £% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.218 \u2014 Paving. 1616 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mai 1966, Tome 88, N° 18 Pour fins d'adjudication seulement, le calcul For purposes of adjudication only, interest d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1956.shall he computed as from June 1st, 1956.Le tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amorti use m cut \u2014 820,000.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er juin 1957.$ 500.00 1er juin 1958.500.00 1er juin 1959 .500.00 1er juin 1900 .500.00 1er juin 1901.500.00 1er juin 1902.1.000.00 1er juin 1903.1.000.00 1er juin 1904.1,000.00 1er juin 1965.1.Q00.00 1er juin I960.1,000.00 1er juin 1967.1.000.00 1er juin 1908.1,000.00 1er juin 1909.1,000.00 1er juin 1970.1,000.00 1er juin 1971.1.000.00 1er juin 1972.1,500.00 1er juin 1973.1.500.00 1er juin 1974.1,500.00 1er juin 1975.1,500.00 1er juin 1976.1,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il.y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Waterloo, comté de Shefford.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Waterloo, comté de Shefford.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.\u2022 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 22 mai 1950, à 8.00 heures p.m.en l'Hôtel de Ville, 580 rue Principale, Waterloo, comté de Shefford.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Waterloo, (Comté de Shefford), ce 27 avril 1950.Le Secrétaire-trésorier.J.-A.RENAUD.CP.50, Hôtel (le Ville.580 rue Principale, Waterloo, (Comté de Shefford), P.Q.42326-o Table of redemption \u2014 $20,000.00 \u2014 20 years.Year Capital June 1st, 1957.$ 500.00 June 1st, 1958.500.00 June 1st, 1959.500.00 June 1st, 1960.500.00 June 1st, 1961.t.500.00 June 1st, 1962.1,000.00 June 1st, 1903.1,000.00 June 1st, 1904.1,000.00 June 1st, 1965.1,000.00 June 1st, 1966.1,000.00 June 1st, 1967.1,000.00 June 1st, 1968.1,000.00 June 1st, 1969.1,000.00 June 1st, 1970.1,000.00 June 1st, 1971.1,000.00 June 1st, 1972.l',500.00 June 1st, 1973.1,500.00 June 1st, 1974.1,500.00 June 1st, 1975.1,500.00 June 1st, 1976.1,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Waterloo, county of Shefford.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Waterloo, county of Shefford.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for .payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenderss will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, May 22, 1956, at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, 580 Principal Street, Waterloo, county of Shefford.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Waterloo, (County of Shefford), April 27, 1950.J.-A.RENAUD, Secretary-Treasurer.P.O.Box 50, Town Hall, 580 Principal St., Waterloo, (County of Shefford), P.Q; 42320 Ventes \u2014 Loi de faillite Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure N° 3201 (1955) \"En Faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Georges Leroux, commis, Coteau du Lac comté de Vaudreuil-Soulanges, Que., débiteur et J.Alexandre Dan-sereau, syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Sales \u2014 Bankrupcy Act Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court No.3201 (1955) \"Sitting in Bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of : Georges Leroux, clerk, Coteau du Lac, county of Vaudreuil-Soulanges, Que., debtor and J.Alexandre Dansereau, Trustee.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 6th, 1956, Vol.88, No.18 1617 Désignation: Un emplacement situé clans le village de Coteau-du-Lac connu et désigné comme étant le lot numéro dix du lot originaire cent quatorze (114-10) aux plan et livre de renvoi officiels de St-Ignace de Coteau-du-Lac, avec bâtisses dessus érigées.Sera vendu, en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, pour le district de Montréal, (en faillite) rendu le 12 avril 1950, à l'enchère publique suivant la Loi pour ladite vente avoir l'effet du décret forcé au terme du Code de procédures civiles, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Ignace de Coteau-du-Lac, Que., SAMEDI, le NEUVIÈME jour de JUIN 1950 à TROIS heures de l'après-midi.Conditions: comptant.En plus, du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges, s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 17ème jour d'avril 1950.Le Syndic, J.ALEXANDRE DANSEREAU.Bureau de: J.Alexandre Dansereau, syndic, 31, rue St-Jacques Ouest, Montréal, P.Q, BE-3324.42270-17-2-o Canada, Province de Québec, district de Québec, Cour Supérieure, (En Matière de Faillite).Dans l'affaire de la faillite de: Legendre Automobile Inc., corps politique et incorporé ayant sa place d'affaires à Montmagny, Que., garagistes, débitrice.AVIS DE VENTE Avis est par les présentes donné que VENDREDI, le HUIT JUIN 1956, à ONZE heures de l'avant-midi, sera vendu par encan public, à la porte de l'église de la ville de St-Thomas de Montmagny, comté de Montmagny, l'immeuble ci-après décrit, savoir: Item A) Un terrain situé sur la rue St-Étienne de la ville de Montmagny, avec le garage y érigé lequel terrain fait partie du lot N° 73 soixante-treize du cadastre officiel pour la ville de Montmagny, de forme irrégulière et borné comme suit: au nord partie par la rue St-Étienne et Clément Rouleau, M.V.(Ptie.N° 73) et mesurant respectivement 51.8 pi.et 33.2 pi., à l'est par partie du lot appartenant à Clément Rouleau, M.V.et partie à la propriété de Louis-Georges Talbot (lot 74) et mesurant respectivement 36 pi.et 60.0 pi., au sud par les lots Nos 75 et parties du lot 72 appartenant respectivement au Dr.Jean-Marie Couillard, Paul-Henri Le-mieux et Roger Boulanger et à l'ouest par le lot N° 71 appartenant à Met le A.Cloutier et par le lot N° 70 appartenant à Monsieur Joseph Bcau-doin.Le tout tel que mentionné à un plan préparé en date du G décembre 1955 par monsieur J.A.Lafleur, arpenteur-géomètre, de la cité de Québec, et d'un procès-verbal de bornage accompagnant cedit plan.Cet item sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et autres servitudes qui peuvent exister.L'acquéreur de cet immeuble devra respecter le bail actuellement existant entre les syndics et le Ministère de la Défense Nationale; lequel bail expirera le 10 septembre 1956 et l'acquéreur aura le droit de percevoir le loyer à compter du premier juin 1956.Description: An emplacement situated in the village of Coteau-du-Lac known and designated as being lot number ten of original lot one hundred and fourteen (114-10) on the official plan and book of reference of St.Ignace de Coteau-du-Lac, with buildings erected thereon.Shall be sold by virtue of a judgment of the Superior Court, for the district of Montreal, (Sitting in Bankruptcy) rendered April 12, 1956, by public auction according to the law, the said sale having the effect of a forced sale in the terms of the Code of Civil Procedure, at the door of the Parochial Church of the Parish of St.Ignace of Coteau-du-Lac, Que., SATURDAY, the NINTH day of JUNE 1956, at THREE o'clock in the afternoon.Conditions: cash.Over and above the purchase price, the pur-shall pay a Government tax of 2%%> in accordance with the law.For further information and the list of charges, application should be made to the undersigned.Dated at Montreal, this 17th, day of April 1956.J.ALEXANDRE DANSEREAU, Trustee.Office of: J.Alexandre Danserea*b, trustee, 31 St.James Street, West, Montreal, P.Q.BE-3324.42270-17-2 Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court, (Sitting in Bankruptcy).In the matter of Legendre Automobile Inc., a body politic and incorporated, having its place of business at Montmagny, Que., garage-keepers, debtor.NOTICE OF SALE Notice is hereby given that FRIDAY, JUNE EIGHTH, 1950, at ELEVEN o'clock in the forenoon, there will be sold, by public auction, at the church door of the town of St.Thomas of Montmagny, county of Montmagny, the immoveable hereinafter described, to wit: Item A) A plot of land situated on St.Etienne Street, of the town of Montmagny, with the garage thereon erected, which plot of land forms part of lot No.73, seventy-three of the official cadastre of the town of Montmagny, of irregular form and bounded as follows: on the north, partly by St.Etienne Street and Clément Rouleau, M.V.(Pt.No.73) and measuring respectively 51.8 ft.and 33.2 ft., on the east, by part of lot belonging to Clément Rouleau, M.V., and partly by the property of Louis-Georges Talbot (lot 74) and measuring respectively 30 ft.and 60.6 ft., on the south, by lots Nos.75 and parts of lot 72, belonging respectively to Dr.Jean-Marie Couillard, Paul-Henri Lemieux and Roger Boulanger and on the west by lot No.71, belonging to Miss A.Cloutier and by lot No.70 belonging to Mr.Joseph Beaudoin.The whole as mentioned on a prepared plan dated December 6, 1955 by Mr.J.A.Lafleur, surveyor, of the city of Quebec, and in the Minutes of a boundary accompanying the said plan.This item shall be offered for sale to the highest and last bidder, subject to existing rents and other servitudes which may exist.The purchaser of this immoveable must respect the lease which presently exists between the trustees and the Department of National Defence; which lease shall expire on September 16, 1956 and the purchaser shall have the right to collect the rent as from June first, 1956. 1018 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mai 1956, Tome 88, N° 18 Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code de Procédure Civile et aussi à l'article 55 de la Loi dc Faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Daté à Québec, ce 27 avril 1956.Les Co-Svndics, JOSEPH MARMETTE & MAURICE BOULANGER.111, Côte de la Montagne, Québec.71, rue St-Picrre, Québec.42331-18-2-o The titles and certificate may be seen at any time at the offices of the undersigned trustees.The said sale is made in conformity with articles 716, 717 and 719A of the Code of Civil Procedure, and also section 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale to have the effect of a Sheriff's sale.Conditions of payment: Cash.Dated at Quebec, April 27, 1956.JOSEPH MARMETTE & MAURICE BOULANGER, Co-Trustees.Ill, Mountain Hill, Quebec, 71, St.Peter Street, Quebec.42331-18-2 Vente pour taxes Province de Québec Municipalité scolaire de Saint-Blaise (Section Ville de Barville) Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-après décrits seront vendus aux enchères à l'Hôtel de Ville de Barville, MERCREDI, le TRENTIÈME jour de MAI en.l'année dix-neuf cent cinquante-six, à DIX heures du matin pour les taxes scolaires et municipales, avec les intérêts et ducs tel que mentionnés ci-après, à moins que les taxes et cotisations ducs pour tels immeubles plus les taxes municipales, ainsi que les frais ne soient acquittés avant la date de la vente à l'enchère, à savoir: Sale for Taxes Province of Quebec School Municipality of Saint-Blaise (Section Town of Barville) Public notice is hereby given that the immoveables hereinafter described shall be sold at auction at the Town Hall of Barville, WEDNESDAY, the THIRTIETH day of MAY in the year nineteen hundred and fifty-six, at TEN o'clock in the morning for the school and municipal taxes, with interests and dues such as mentioned hereinafter, unless the taxes and assessments due on such immoveables, plus the municipal taxes, as well as the costs, are acquitted before the date of the auction sale, to wit: Propriétaire Owner Rang Range N° do cadastre No.of cadastre Taxes 8col.School taxes Taxes munie.Munie, taxes Total Jos Filion.J.Alexis Bélec.Ls.Georgo Boulé.Jean M.Bissonnette.Adélard Masse.Lucien Domers.Edouard Filiatrault.Maurice Magny.Maurice Magny.Ls.Georges Boulé.Conrad Défossé.Georges A.Tardif.Georges A.Tardif.Lionel Dallaire.Maurice Beaumier.Maurice Beaumier.Maurice Beaumier.Armand Morissette.Paul Emile Lafontaine.Dame Levis Beaudoin.Maurice Magny.Wilfrid Lemay.Armand Morissette.Willie Goyet.Elphége Plourde.Armand Dumas.Armand Dumas.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VII VII VII VII VII VII VII 25-27.26-28.28-25.28-105.28-141.28-142.28-148.28-153.28-154.29-42.29-46.28-55.29-56.29-59.29-66.29-67____.29-68.30-3.30-27.30-62.35-Subd.25-Subd.27-2.27-3.27-44.28-Subd.ouest-west 28-Subd.est-east.$ 18.95 53.80 62.60 42.75 78.30 22.95 46.80 13.60 12.30 62.40 48.00 38.95 38.95 42.60 20.85 23.70 28.70 88.10 73.40 14.85 149.30 286.60 105.80 260.80 37.40 284.50 335.65 3 7.63 21.57 27.41 22.02 18.53 20.53 10.06 9.47 30.90 21.43 19.34 19.34 17.84 20.53 17.24 17.24 31.59 35.18 10.97 29.04 55.72 46.04 19.11 7.20 145.52 182.89 * 26.58 75.37 90.01 64.77 78.30 41.48 67.33 23.66 21.77 93.30 69.43 58.29 58.29 60.44 41.38 40.94 45.94 119.69 108.58 25.82 178.34 342.32 151.84 279.91 44.60 430.02 518.54 Tous les immeubles ci-dessus sont sur le plan et livre de renvoi de la ville de Barville, Abitibi-Est.L'acheteur doit payer comptant ou par chèque certifié immédiatement après la vente.Donné en la Ville de Barville, ce dix-septième jour d'avril, en l'année dix-neuf cent cinquante-six.Le Secrétaire-trésorier, 42328-18-2-0 ROSARIO ROCK.All the immoveables hereinabove are on the plan and in the book of reference of the town of Barville, Abitibi-East.Purchaser must pay cas or by certified cheque immediately after the sale.Given in the town of Barville, this seventeenth day of April, in the year nineteen hundred and fifty-six.ROSARIO ROCK, 42328-18-2 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 5th, 1956, Vol.88, No.18 1619 VENTES PAR SHERIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par Ie present donné que PUBLIC NOTICE is hereby given that the les TERRES ET HERITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.HULL District de Hull Cour Supérieure, ( \"P\\A M E L U MIN A LA-N° 4564.-j POINTE, veuve de v.Jean-Baptiste Pharand, de son vivant marchand, dc la cité de Hull, tant personnellement qu'en sa qualité d'exécutrice testamentaire, demanderesse, vs DAME FLORIDA CLAIRMONT, veuve de R.Madore ci-devant de la cité de Hull, et maintenant de lieux inconnus, défenderesse.\"Toute cette propriété connue et désignée comme étant la subdivision numéro cent cinquante-sept du lot numéro cent trente-cinq du cadastre pour le quartier numéro trois de la cité de Hull et les bâtisses dessus construites\".Pour être vendue à mon bureau, au Palais de Justice, en la cité de Hull, dit district, le DIX-HUITIÈME jour de MAI prochain, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST.PIERRE, ce 7 avril, 1956.42174-15-2-0 IBERVILLE Canada, Province de Québec District d'Rjerville Cour Supérieure, ( t R.SICOTTE, commerçant N° 8640.{ j \u2022 de la paroisse de St-Pa-\\ trice de Sherrington, district d'R)crville, demandeur vs HORACE SÉNÉCAL, du même lieu, défendeur, Saisi et pris en exécution comme appartenant au dit défendeur, les immeubles ci-après désignés, savoir: 1.Du lot connu et désigné sous le N° cent cinquante (150) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Patrice de Sherrington, contenant en superficie dix-huit arpents, (18) 2.Du lot connu et désigné sous le numéro cent quarante-neuf (149) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Patrice de Sherrington, contenant cinq arpents (5) en superficie.3.Du lot connu et désigné sous le numéro cent quarante-huit (148) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Patrice de Sherrington, mesurant en front deux arpents sur treize arpents et quart de profondeur, contenant en superficie vingt-six arpents et cinquante perches.4.Une partie du lot connu et désigné sous le numéro cent quarante-six (146) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la dite paroisse de St-Patrice de Sherrington, contenant environ sept arpents de largeur sur la distance qu'il y a à partir du rang de Bagnole jusqu'à la \"petite Rivière\" de Montréal, en suivant le trait carré des terres de Domina Sicotte et de J.B.Faille à la ligne de Joachin Lefebvre, formant une superficie de cinquante arpents plus ou moins, avec une maison et autres bâtisses dessus construites.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de St-Patrice de Sherrington, JEUDI, le SEPT JUIN, 1956 à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RICHARD MERCIER.Saint-Jean, le 28 avril 1956.42345-18-2-o iperior Court, ( T No.4564.{ i-Uis HULL District of Hull Superior Court, ( T\\\\ME LUMINA LAPOIN-¦*-*' TE, widow of Jean-Baptiste Pharand, in his lifetime a merchant, of the city of Hull, both personally and in her capacity of Executrix, plaintiff; vs DAME FLORIDA CLAIRMONT, widow of R.Madore, formerly of the city of Hull and now of unknown whereabouts, defendant.\"All that property known and designated as being subdivision number one hundred and fifty-seven of lot number one hundred and thirty-five of the cadastre for Ward number 3 of the city of Hull and the buildings erected thereon\".To be sold at my office, at the Court House, in the city of Hull, said district, the EIGHTEENTH day of MAY next, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST.PIERRE, Sheriff's Office, Sheriff.April 7, 1956.42174-15-2 IBERVILLE Canada, Province of Quebec District of Rjerville Superior Court, No.8640.( t R.SIO < j \u2022 of the v trice dc Sh R.SICOTTE, merchant, i parish of St.Pa-Sherrington, district of Dîcrville, plaintiff vs HORACE SÉNÉCAL, same locality, defendant.Seized and taken in execution as belonging to said defendant, the immoveables hereinafter designated, to wit: 1.Lot known and designated as No.one hundred and fifty (150) on the official plan and book of reference of the parish of St.Patrice de Sherrington, containing an area of eighteen arpents (18).2.Lot known and designated as number one hundred and forty-nine (149) on the official plan and book of reference of the Parish of St.Patrice de Sherrington, containing an area of five (5) arpents.3.Lot known and designated as number one hundred and forty-eight (148) on the official plan and a book of reference of the parish of St.Patrice de Sherrington, measuring, in front, two arpents by thirteen and one quarter in depth, containing an area of twenty-six arpents and fifty rods.4.A part of lot known and designated as number one hundred and forty-six (146) on the official plan and book of reference of the said parish of St.Patrice de Sherrington, containing some seven arpents in width by the distance that exists as from Bagnole Range as far as \"Petite Rivière\", of Montreal, following the range line of the farms of Domina Sicotte and J.B.Faille to the line of Joachin Lefebvre, forming an area of fifty arpents, more or less, with a house and other buildings erected thereon.To be sold at the door of the Church of the Parish of St.Patrice de Sherrington, THURSDAY, the SEVENTH day of JUNE, 1956, at ELEVEN o'clock in the forenoon.RICHARD MERCIER.Sheriff's Office, Sheriff.Saint John, April 28th, 1956.42345-18-2 1620 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 4 mai 1956, Tome 88, N° 18 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour de Magistrat, i t B.LA VOIE, avocat de N° 1045.< j \u2022 la cité dc Rivicrc-du-l Loup, demandeur; vs JOSEPH DESCHÊNES, de Saint-Bruno, défendeur.Les lots dc terre numéros vingt (20).rang cinq (5) vingt-cinq (25), rang trois (3), canton Wood-bridge, et le lot numéro vingt-trois (23) rang cinq (5) du même canton.Le tout, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Bruno, comté de Kamouraska, VENDREDI, le DIX-HUITIÈME jour de MAI 1950, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.-E.MARTIN.Rivière-du-Loup, 9 avril 1950.42187-15-2-0 [Première insertion, samedi le 14 avril, 1956] KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Magistrate's Court, / t B.LA VOIE, attorney No.1045.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.