Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 9 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1956-06-09, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tomb 88, N9 23 1951 Vol.88, No.23 ; - \u2022\t *\t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 9 juin 1956 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 9th, 1956 \u2014j NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1952 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° S3 délai pour la réception des avis, documents'ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502-1-52 Lettres patentes (P.G.11167-56) Alphonse Morency & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1956, constituant en corporation: Jean-Pierre Morency, Alphonse Morency, plombiers-électriciens, et Gratia Pruneau Morency, ménagère, épouse séparée de biens dudit Alphonse Morency, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage, électricité, réfrigération, climatisation d'air et posage d'appareils extincteurs d'incendie, sous le nom de \"Alphonse Morency & Fils Ltée\", avec un capital total de $75,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $25 chacune et en 25,000 actions privilégiées de $1 chacune Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.Letters Patent (A.G.11167-56) Alphonse Morency & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of April, 1956, incorporating: Jean-Pierre Morency, Alphonse Morency, plumbers-electricians, and Gratia Pruneau Morency, housewife, wife separate as to property of the said Alphonse Morency, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as contractors in plumbing, heating, electricity, refrigeration, air conditioning, and the installation of fire extinguishers, under the name of \"Alphonse Morency & Fils Ltée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 2,000 common shares of $25 each and into 25,000 preferred shares of $1 each.The head office of the Company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 1953 (P.G.10983-56) American Electronics Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1956, constituant en corporation: Paul M.Cîervais, avocat, Fernande B.Thibault, sténographe, épouse séparée de biens de Jules Thibault et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, et Emile Gagnon comptable agréé, tous de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme électriciens et travailleurs d'appareils électriques électroniques de radio et radar et manufacturiers de dispositifs et accessoires électriques et électroniques, sous le nom de \"American Electronics Company Ltd.\", avec un capital total/le $70,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 85 chacune et 2,500 actions privilégiées de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11111-56) A.Pilon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1956, constituant en corporation: Albini Pilon, industriel et commerçant, de Verdun Jean F.Laureys, avocat, de Westmount, et Pal-ména Pelletier, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de combustibles et lubrifiants, sous le nom de \"A.Pilon Inc.\", avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social de la compagnie sera 1146 rue Hickson, Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.10909-56) Arthur Brault Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mars 1956, constituant en corporation: Arthur Brault, marchand, Dame Virginie Billette, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Arthur Brault, et Jean-Louis Bertrand, contremaître.tous de Howick, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Faire affaires comme meunier, exploitant de scierie et exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Arthur Brault Limitée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Howick, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(A.G.10983-56) American Electronics Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April, 1956, incorporating: Paul M.Gcrvais, Lawyer, Fernande B.Thibault, stenographer, wife separate as to property of Jules Thibault and duly authorized by him for the purpose of these presents, and Emile Gagnon, Chartered Accountant, all of Sherbrooke, judicial district of St-François, for the following purposes: To carry on the business of electricians, electrical, electronic, radio and radar workers and manufacturers of electric and electronic appliances and accessories, under the name of \"American Electronics Company Ltd.\", with a total capital stock of $70,000, divided into 4,000 common shares of $5 each and into 2,500 preferred shares of $20 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St-François.Dated at the office of the Attorney General, this third day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11111-56) A.Pilon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: Albini Pilon, industrialist and merchant, of Verdun, Jean F.Laureys, advocate, of Westmount and Palména Pelletier, secretary, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in fuels and lubricants, under the name of \"A.Pilon Inc.\", with a capital divided into 1,000 without nominal or par value.The head office of the Company will be at 1140 Hickson, Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10909-56) Arthur Brault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second March, 1956, incorporating: Arthur Brault, merchant, Dame Virginie Billette, housewife, wife contractually separate as to property of the said Arthur Brault, and Jean-Louis Bertrand, foreman, all of Howick, judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To carry on business as miller, operator of sawmill and deal in building materials, under the name of \"Arthur Brault Limitée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Howick, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of March, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General. 1954 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 28 (P.G.10997-56) Astra Trading Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation: Samuel Godinsky.Frank M.Godine, avocats, et Moe Silverstein, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce ou le négoce d'appareils de photographie et articles de sport, sous le nom de \"Astra Trading Corp.\", avec un capital total de 800,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1950.L-Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11005-56) Baker Development Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: John Todd, étudiant, de Westmount.William Johnston, notaire, de Lachine, et Léonard Charles Bull, gérant de bureau, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Baker Development Corporation Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions d'une valeur nominale ou au pair de 84 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 ' P.FRENETTE.(P.G.10971-50) Béchard Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compangies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1956, constituant en corporation: Roger L.Beaulicu, avocat, de Côte St-Luc, George A.Allison, avocat, de Ville Mont-Royal, et Pierre R.D.MacKell, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de véhicules automobiles; agir comme garagiste, sous le nom de \"Béchard Automobile Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1950.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.10802-50) Bernley Investment Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.10997-56) Astra Trading Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: Samuel Godinsky, Frank M.Godine, advocates, and Moe Silverstein, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To man niacin re and deal in or with photographic equipment and sporting goods, under the name of \"Astra Trading Corp.\", with a total capital stock of $00,000, divided into 100 common shares having a par value of $100 each and into 500 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11065-56) Baker Development Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: John Todd, student, of Westmount, William Johnston, notary, of Lachine, and Leonard Charles Bull, office manager, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general real estate and construction business, under the name of \"Baker Development Corporation Ltd.\", with a total capital stock of 8-10,000, divided into 10,000 shares with a nominal or par value of $4 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10971-50) Béchard Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1956, incorporating: Roger L.Beaulieu, advocate, of Côte St.Luc, George A.Allison, advocate, of the Town of Mount Royal, and Pierre R.D.MacKell, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate a business of motor vehicles; act as garage-keeper, under the name of \"Béchard Automobile Ltée\", with a total capotai stock of 820,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of March, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10802-50) Bernley Investment Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol 88, No.28 1955 été accordé parle Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du sept avril, 1950 constituant en corporation: Morrie Levy, marchand, de Westmount, David Bernstein, marchand et Morris Nusselman, gérant, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de prêts sous le nom de \"Bernley Investment Co.\", avec un capital total de §225,000 divisé en 2,500 actions ordinaires de 810 chacune et 20,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11568-56) Black Top Asphalt Paving Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mai 1956, constituant en corporation: Paul IL Lévesque, avocat, de Ville Mont-Royal, Gertrude St-Onge, secrétaire, fille majeure, et Alcide Grenon, comptable, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme paveurs, carriers et marchands de pierre, sous le nom de \"Black Top Asphalt Paving Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11087-50) Bonne-Terre Development Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1950, constituant en corporation: Murray B.Spiegel, Harry Pinker, avocats, et Nina Schlesinger, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire .de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou intérêts en iceux, ériger des bâtisses et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Bonne-Terre Development Company\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11089-50) Bouchervillc Entreprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, incorporating: Morrie Levy, merchant, of Westmount, David Bernstein, merchant, and Morris Nusselman, manager, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and loan company, under the name of \"Bernley Investment Co.\", with a total capital stock of 8225,000, divided into 2,500 common shares of 810 each and into 20,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of April, 1950, P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11568-56) Itluck Top Asphalt Paving Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of Maj', 1956, incorporating - Paul IL Lévesque, advocate, of the town of Mount Royal, Gertrude St-Ongc, secretary, spinster of age, and Alcidc Grenon, accountant, of Montreal, all of the judicial district of \"Montreal, for the following purposes: To carry on business as pavers, quarry masters and stone merchants, under the name of \"Black Top Asphalt Paving Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 250 common shares of the par value of $100 each and into 750 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11087-50) Bonnc-Terre Development Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1950, incorporating: Murray B.Spiegel, Harry Pinker, advocates, and Nina Schlesinger, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire lands or interests therein; to erect buildings and to deal in building material, under the name of \"Bonne-Terre Development Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of 810 each and into 3,600 preferred shares of a par value of S10 each.The head offict of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11089-56) Bouchervillc Entreprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1956 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° ZS été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1956, constituant en corporation: Emé Lacroix, C.R., avocat, de Ville Mont-Royal, Armand Poupart, fils, avocat, et Monique Duquette, sténographe, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneur général et constructeur, sous le nom de \"Bouchervillc Entreprises Inc.\", avec un capital total de $500,000, divisé en 4,500 actions privilégiées de $100 chacune et en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11066-56) Bristol Cultery Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: Alec Lewis, administrateur, Michael Greenblatt et Samuel Godinsky, tous deux avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pouv les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce et le négoce de coutellerie, parties constituantes, ferronnerie, accessoires d'icelle, outils, sous le nom de \"Bristol Cutlery Company\", avec un capital total de $150,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera cà Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11202-56) Bureau de l'Industrie et du Commerce de Québec Métropolitain, Inc.Industrial and Trade Bureau of Greater Quebec, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Longy, A.-Fré-déric Mercier, industriels, Henri-F.Béique, ingénieur professionnel, Roger Vézina, avocat, de Sillery, Jean-Marie Martin, professeur à Laval, d'Orsainvelle, et Isidore C.Pollack, négociant, de Sainte-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Protéger et promouvoir les intérêts économiques du district de Québec, sous le nom de \"Bureau de l'Industrie et du Commerce de Québec Métropolitain, Inc.\u2014 Industrial and Trade Bureau of Greater Quebec, Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: Emé Lacroix, Q.C., advocate, of the town of Mount Royal, Armand Poupart, junior, advocate, and Monique Duquette, stenographer, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveables; to carry on business as general contractor and builder, under the name of \"Bouchervillc Entreprises Inc.\", with a total capital stock of $500,000, divided into 4,500 preferred shares of $100 each and 5,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at in the city of Saint Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11066-56) Bristol Cultery Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Alec Lewis, executive, Michael Greenblatt and Samuel Godinsky, both barristers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with cutlery, components thereof, hardware, hardware supplies, tools, under the name of \"Bristol Cutlery Company\", with a total capital stock of $150,000, divided into 250 common shares having a par value of 8100 each and into 1,250 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11202-56) Bureau de l'Industrie et du Commerce de Québec Métropolitain, Inc.Industrial and Trade Bureau of Greater Quebec, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Jean Longy, A.Frederic Mercier, industrialists, Henri F.Béique, professional engineer, Roger Vézina, advocate, of Sillery, Jean-Marie Martin, professor at Laval, of Orsainville, and Isidore C.Pollack, dealer, of Sainte-Foy, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes : To protect and promote the economical interests of the district of Quebec, under the name of \"Bureau de l'Industrie et du Commerce de Québec Métropolitain, Inc.\u2014 Industrial and Trade Bureau of Greater Quebec, Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol 88, No.28 1957 Daté du bureau du Procureur généra], le vingt-quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11028-56) Canada Dry Delivery Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1956, constituant en corporation: Fernand Si mi s, comptable agréé, Roméo Gingras, camionneur, Rosée Dubois, ménagère, épouse commune en bien dudit Roméo Gingras, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous trois de Québec, et Marcel Sirois, distributeur, de Sainte-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de transport, sous le nom de \"Canada Dry Delivery Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.11099-56) Car-Len Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Harry Blank, Raymonde Doyle, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, Baruch Pollack, avocat, d'Outremont et Gloria Williams, secrétaire, fille majeure, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire, exploiter, administrer et diriger des restaurants, sous le nom de \"Car-Len Enterprises Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur généra], le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11107-56) Central Art Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1956, constituant en corporation: Irving J.Halperin, avocat, Elie Halperin, teneur de livres, Harry Biskin, vendeur et Grace Feil, secrétaire, fille majeure, tous dea cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Dessiner, reproduire et faire le commerce d'un service de publicité, copies, photographier et photographies commerciales, art commercial et tous autres articles et choses qui sont nécessaires ou relatives audit commerce, sous le nom de \"Central Art Service Inc.\", avec un capital Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11028-56) Canada Dry Delivery Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1956, incorporating: Fernand Sirois, chartered accountant, Roméo Gingras, trucker, Rosée Dubois, housewife, wife common as to property of the said Roméo Gingras, and duly authorized by him for these presents, all three of Quebec, and Marcel Sirois, distributor, of Sainte-Foy, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the operations of a transportation company, under the name of \"Canada Dry Delivery Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of March, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11099-56) Car-Len Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, incorporating: Harry Blank, Raymonde Doyle, secretary, fiUe majeure, both of Montreal, Baruch Pollack, advocate, of Outrc-mont, and Gloria Williams, secretary, fille majeure, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To build, operate, manage and conduct restaurants, under the name of \"Car-Len Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11107-56) Central Art Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1956, incorporating: Irving J.Halperin, advocate, Elie Halperin, bookkeeper, Harry Biskin, salesman, and Grace Feil, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To design, reproduce and deal in advertising, copy, photographs and commercial photographs, commercial art and such other articles and things as are necessary or incidental to the said business, under the name of \"Central Art Service Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided 195S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 total de $25,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10799-56) Centre de Couleurs Boulevard Color Center Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1956, constituant en corporation: René Beaudry, avocat, de Verdun, Louis-Joseph de la Durantaye, avocat, et Madeleine Besanceney, secrétaire, fille majeure, ces deux derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer une entreprise pour l'embellissement de terrains et de maisons, sous le nom de \"Centre de Couleurs Boulevard Color Center\", avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint -Eustache.district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11090-56) Chambre de Finance Inc.Chamber of Finance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1956, constituant en corporation: Maurice Gagné.Jacques Flynn, avocats et conseils en loi de la Reine, de Québec, et Julien Chouinard, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Chambre de Finance Inc.\u2014 Chamber of Finance Inc.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11147-56) Copper Crop Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1956, constituant en corporation: Robert Lafleur, C.R., avocat, d'Outremont, Paul Alexandre Mo-rel, industriel, de Montréal, et Jules Archambault, ingénieur, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: into 1,000 common shares of a par value of 810 each and into 1,500 preferred shares of a par value of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1950.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10799-50) Centre de Couleurs Boulevard Color Center Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1950, incorporating: René Beaudry.advocate of Verdun, Lou is-Joseph de la Durantaye, advocate, and Madeleine Besab-cenay, secretary, of full age.the latter two of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on an enterprise for the embellishment of grounds and houses, under the name of \"Centre de Couleurs Boulevard Color Center\", with a total capital slock of 840,000, divided into 1.000 common shares of a par value of 810 each and into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Eustache, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of March, 1950.P.FRENETTE, 425-10 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11090-50) Chambre de Finance Inc.Chamber of Finance Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March 1950, incorporating: Maurice Gagné, Jacques Flynn, advocates and Queen's Counsel, of Quebec, and Julien Chouinard, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Chambre de Finance Inc.¦\u2014 Chamber of Finance Inc.\", with a share capital divided into 100 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first dav of March 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11147-56) Copper Crop Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1956, incorporating: Robert Lafleur, Q.C., advocate, of Outremont, Paul Alexandre Morel, industrialist, of Montreal, and Jules Archambault, engineer, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 1959 Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Copper Crop Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de §4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions d'une valeur au pair de §1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FBENETTE.(P.G.11157-56) Çousineau-Gaboury Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze avril 1956, constituant en corporation: Jeanne Gagnon, secrétaire, Léo-C.Marcotte, avocat, et Jacques Vigor, commis de bureau, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie de manufacturiers et raffi-neurs d'huile, graisse, pétrole et de leurs sous-produits et en exercer le commerce, sous le nom de \"Cousineau-Gaboury Ltée\", avec un capital total de §75,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de §100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11210-56) Déménagement Moderne Moving Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1956, constituant en corporation: Edgar Collard, camionneur, de Danville, Luc Bolduc et Roger Maurice, commerçants, d'Asbestos, tous du district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exploiter des entreprises de transport, sous le nom de \"Déménagement Moderne Moving Ltd.\", avec un capital total de §25,000, divisé en 250 actions communes de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dan-ville, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.10933-56).Electrical Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Briskin, avocats, et Jack Klineberg, notaire, To prospect and explore for mines and minerais and deal with same, under the name of \"Copper Crop Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of §4,000,000, divided into 4,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11157-50) Cousineau-Gaboury Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of April, 1956, incorporating: Jeanne Gagnon, secretary, Léo-C.Marcotte, advocate, and Jacques Vigcr, office clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: , To carry on a business dealing in the manufacturing and refining of oil, grease, petrol and their by-products and to deal in same under the name of \"Cousineau-Gaboury Ltée \", with a total capital stock of §75,000, divided into 500 common shares of a par value of §100 each and into 250 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11216-56) Déménagement Moderne Moving Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April 1956, incorporating: Edgar Collard, trucker, of Danville, Luc Bolduc and Roger Maurice, merchants, of Asbestos, all of the judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To engage in transportation undertakings, under the name of \"Déménagement Moderne Moving Ltd.\", with a total capital stock of §25,000, divided into 250 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Danville, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10933-56) Electrical Industries Inc.Notice is hereby given that tinder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Max Liberman, Leonard Liverman, Julius Briskin, advocates, and Jack Klineberg, notary, all of the city and 1960 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1966, Tome 88, N° 28 tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'accessoires électriques et électroniques, sous le nom de \"Electrical Industries Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10650-56) Enseignes Gay Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mars 1956, constituant en corporation: Robert Guay, lettreur, de Québec, Paul Rhéaume, commis de bureau, de Giffard, et Alfred Chamberland, lettreur, de ville Montmorency, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur, décorateur et lettreur et faire tous ouvrages se rapportant aux enseignes de toutes sortes, sous le nom de \"Enseignes Gay Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 180 actions communes de $100 chacune et en 220 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1645, rue d'Assise, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11064-56) E.O'Sullivan (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq avril 1956, constituant en corporation: Roger Louis Beaulieu, Charles A.Phelan, avocats tous deux de Montréal, William Aubrey Tetley et Kenneth Arnold, Frank Gates, avocats, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des propriétés immobilières à des fins de placements et développement, sous le nom de \"E.O'Sullivan (Canada) Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 7,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10952-56) Fiat Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation : judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an electrical and electronics company, under the name of \"Electrical Industries Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10650-56) Enseignes Gay Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of March, 1956, incorporating: Robert Guay, letterer, of Quebec, Paul Rhéaume, office clerk, of Giffard, and Alfred Chamberland, letterer, of the town of Montmorency, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on a business as contractor, decorator and letterer and to do all the work pertaining to signs of all kinds, under the name of \"Enseignes Gay Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 180 common shares of $100 each, and into 220 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1645 Assise St., Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this first day of March, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11064-56) E.O'Sullivan (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April, 1956, incorporating: Roger Louis Beau-lieu, Charles A.Phelan, advocates, both of Montreal, William Aubrey Tetley and Kenneth Arnold Frank Gates, advocates, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire immoveable property for the purposes of investment and development, under the name of \"E.O'Sullivan (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of the par value of $1 each and into 7,000 preferred shares of the par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10952-56) Fiat Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April 1956, incorporating: André Nadeau, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.28 1961 André Nadeau, avocat, de Saint-Lambert, Jean-Marie Nadeau, avocat, et Pierrette Morel, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Fiat Construction Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3597, rue Joliette, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11114-56) Fournier Van & Storage (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1956, constituant en corporation: Jacques Décary, de Strathmore, Georges Bilo-deau, de Montréal-Nord, et Rhéal Brunet, de Montréal, tous avocats, du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de transport et d'entreposage, sous le nom de \"Fournier Van & Storage (Quebec) Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 25,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11332-56) Grindstone Garage Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1956, constituant en corporation: Raymond Maher, avocat, Jeanne Prévost, secrétaire, épouse séparée de biens d'Omer Prévost, de Québec, et Jean-Charles Lord, avocat, de Beauport, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de véhicules automobiles et machineries lourdes et exploiter des garages, sous le nom de \"Grindstone Garage Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cap-aux-Meules, district judiciaire de Gaspé.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11501-56) Hôpital des Laurentides Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du huit mai 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Lucien Cyr, notaire, Georges Peclet, agent, et Onésime Noël, marchand, advocate, of Saint Lambert, Jean Marie Nadeau, advocate, and Pierrette Morel, secretary, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of builders and general contractors, under the name of \"Fiat Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 3597 Joliette Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11114-56) Fournier Van & Storage (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1956, incorporating: Jacques Décary, of Strathmore, Georges Bilodeau, of Montreal-North, and Rhéal Brunet, of Montreal, all advocates, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a transportation and warehousing company under the name of \"Fournier Van & Storage (Quebec) Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 25,000 common shares of a par value of $1 each and into 500 preferred shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11332-56) Grindstone Garage Limited Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1956, incorporating: Raymond Maher, advocate, Jeanne Prévost, secretary, wife separate as to property of Oiner Prévost, of Quebec, and Jean-Charles Lord, advocate, of Beauport, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in motor vehicles and heavy machinery and to-operate garages, under the name of \"Grindstone Garage Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Cap-aux-Meules, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11501-56) Hôpital des Laurentides Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Lucien Cyr, notary, Georges Pelcet, agent, and Onésime Noël, merch- 1962 GAZKTTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1965, Tome 88, N° 23 tous de l'Annonciation, district judiciaire de Labelle, pour les objets suivants: Assumer l'administration d'un hôpital pour malades mentaux, sous le nom de \"Hôpital des Laurent ides\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8600,000.Le siège social de la corporation sera à l'Annonciation, district judiciaire de Labelle.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.11062-56) Ideal Steak-House Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: Raymond Lebœuf, LL.L., avocat.Êphraim Lebœuf, C.R., avocat, et Maurice de Bèllefeuille, courtier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateur, sous le nom de \"Ideal Steak-House Inc.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de .Tolictte.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.10408-56) Illustrated Technical Products of Canada Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1956, constituant en corporation: Louis IL Rohrlick, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Paul L.Gordon, avocat, et Thelma Goldstein, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires qui consistent à compiler, publier, manufacturer et faire le commerce de manuels techniques, dépliants, livres, revues et autres publications, sous le nom de \"Illustrated Technical Products of Canada Ltd.\", avec un capital total de 85,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.^ Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10965-56) Immeubles Dicaire Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1956, constituant en corporation: Albert Dicaire, Georges Dicaire, agents d'immeubles, de Lachine, et Paul-Émile Savage, notaire, ant, all of L'Annonciation, judicial district of Labelle, for the following purposes: To assume the management of a hospital for mental patients, under the name of \"Hôpital des Laurent ides\", The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8600.000.The head office of the company will be at L'Annonciation, judicial district of Labelle.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of May, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11062-56) Ideal Steak-House Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Raymond Lebœuf, LL.L., advocate, Êphraim Lebœuf, Q.C., advocate, and Maurice de Bèllefeuille, broker, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurateur, under the name of \"Ideal Steak-House Inc.\", with a total capital stock of 820.000, divided into 2,000 common shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 12540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10408-56) Illustrated Technical Products of Canada Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1956, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, Paul L.Gordon, advocate, and Thelma Goldstein, secretary, spinster of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of compiling, editing, manufacturing and deal in technical manuels, folders, books, periodicals and other publications, under the name of \"Illustrated Technical Products of Canada Ltd.\", with a total capital stock of 85,000, divided into 100 common shares of the par value of 810 each and into 400 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10965-56) Immeubles Dicaire Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April 1956, incorporating: Albert Dicaire, Georges Dicaire, real estate agents, of Lachine and Paul-Êmile Savage, notary, of Montreal, all QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 1963 de Montreal, tous du district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Immeubles Dicaire Realties Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera 275, 8ième avenue, Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau dû Procureur général, le dix avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11567-56) Immeubles Van Park Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mai 1956, constituant en corporation: Alcide Grenon, comptable, Gertrude St-Onge, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Paul IL Lévesque, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels et restaurants: administrer et exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Immeubles Van Park Ltée\", avec un capital total de $60,000, divisé en 600 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.10879-56) J.A.Tremblay Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1956, constituant en corporation: J.-Albert Tremblay, commerçant, Gisèle Bienvenue Tremblay, ménagère, épouse séparée de biens de J.-Albert Tremblay, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Léo Roy, commis, tous d'Alma, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchandises, produits et articles faits en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre, et les sous-produits d'iceux, de vêtements, de meubles, d'accessoires et appareils d'utilité domestique, sous le nom de \"J.A.Tremblay Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 70, rue Sacré-Cœur, Aima, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mars 1950.L'Assistant-procureur général, suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11148-56) Jean-Marc Habel, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Immeubles Dicaire Realties Inc.\", with a total capital of 840,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $25 each.The head office of the Company will be at 275, 8th Avenue, Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Dpeuty Attorney General.(A.G.11567-56) Immeubles Van Park Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of May 1956, incorporating: Alcide Grenon, accountant, Gertrude St-Onge, secretary, fille majeure, both of Montreal, and Paul H.Lévesque, advocate, of the Town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate hotels and restaurants; to deal in real estate and deal in same, under the name of \"Immeubles Van Park Ltée\", with a total capital stock of $60,000, divided into 600 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of May 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10879-56) J.A.Tremblay Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1956, incorporating: J.Albert Tremblay, dealer, Gisèle Bienvenue Tremblay, housewife, wife separate as to property of J.Albert Tremblay, and duly authorized by him for these presents, and Léo Roy, clerk, all of Alma, judicial district of Roberval, for the following purposes: To deal in merchandise, products and articles made in whole or in part of leather, rubber, metal, mettaloid, wood, paper, nylon, plastic, fur, textile, glass, and the by-products thereof, in clothing, furniture, accessories and apparatus of domestic utility, under the name of \"J.A.Tremblay Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 70 Sacred-Heart St., Alma judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of March, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11148-56) Jean-Marc Habel, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth 1964 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 du treize avril 1956, constituant en corporation: Jean-Marc Habcl, vendeur, Bernadette Blan-chette, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean-Marc Habel, et dûment autorisée par ce dernier, et Maurice Habel, gérant de ventes, tous de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles, machines à coudre, machines à tricoter, appareils électriques, radios et télévisions, articles de bureau, et les accessoires se rapportant à ces objets, sous le nom de \"Jean-Marc Habel, Limitée\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoria-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le treize avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11068-56) Juventas Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: Melvin Rothman, avocat, de Westmount, Yvonne Bélanger et Sylvia Vineberg, secrétaires, filles majeures, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou intérêts en iceux; exercer le commerce d'entrepreneurs et constructeurs généraux, sous le nom de \"Juventas Investments Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11100-56) King, Stephens Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Louis Abraham DeZwirek, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Daniel Morris, avocat, tous deux de Montréal, et Manuel Shacter, avocat, de Dorval, tous du district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"King, Stephens Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11063-56) La Boutique d'Eve Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: day of April, 1956, incorporating: Jean-Marc Habel, saleman, Bernadette Blanchette, housewife, wife separate as to property of the said Jean-Marc Habcl, and duly authorized by the latter, and Maurice Habel, sales manager, all of Victoriaville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on a business dealing in furniture, sewing machine, knitting machines, electrical applicances, radios and televisions, office articles and accessories pertaining to these objects, under the name of \"Jean-Marc Habel, Limitée\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of April, 1956.P.FRENETTE.42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11068-56) Juventas Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Melvin Rothman, advocate, of Westmount, Yvonne Bélanger and Sylvia Vineberg, secretaries, filles majeures, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire lands or interests therein; to carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Juventas Investments Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11100-56) King, Stephens Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, incorporating: Louis Abraham DeZwirek, advocate and queen's counsel, Daniel Morris, advocate, both of Montreal, and Manuel Shacter, advocate, of Dorval, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"King, Stephens Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and into 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Assistant Deputy Attorney General.(A.G.11063-56) La Boutique d'Eve Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Alban Dufresne, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.S3 1965 Alban Dufresne, artiste commercial, Béatrice Corriveau, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Denise Desroches, secrétaire, fille majeure, de Montréal-Nord, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de bibelots, d'objets d'art et de décoration, jouets, draperies, lingerie, produits d'artisanat, cadeaux, peinture, matériel d'artiste, appareils et accessoires électriques, sous le nom de \"La Boutique d|Ève Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions communes de $50 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawini-gan-Falls, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11103-56) La Cie de Chauffage Pierrefonds Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Gérard Raymond, marchand, de Sainte-Gene-viève-de-Pierrefonds, Jean Provost, comptable agréé, d'Outremont, Jean-Paul Dussault, vendeur, et Charles E.Poirier, notaire, ces deux derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'appareils ou systèmes de chauffage, de climatisation et de réfrigération, sous le nom de \"La Cie de Chauffage Pierrefonds Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15720, Boulevard Gouin, ouest, Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11159-56) La Compagnie des Maisons Modèles Limitée Model Housing Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1956, constituant en corporation : Jérôme Venne, plombier, Ovila Venne, menuisier, tous deux de Hull, et Lionel Tremblay, menuisier, de Masson, tous du district judiciaire de Hull, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"La Compagnie des Maisons Modèles Limitée \u2014 Model Housing Company Limited\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.commercial artist, Béatrice Corriveau, secretary, of full age, both of Montreal, and Denise Desroches, secretary, of full age, of Montreal-North, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and carry on a business dealing in trinkets, articles of art, and decorative articles, toys, draperies, lingerie, homespun products, gifts, paints, artists' materials, electrical apparatus and accessories, under the name of \"La Boutique d'Eve Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $50 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Shawinigan-Falls, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11103-56) La Cie de Chauffage Pierrefonds Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, incorporating: Gérard Raymond, merchant, of Sainte-Geneviève-de-Pierre-fonds, Jean Provost, chartered accountant, of Outremont, Jean-Paul Dussault, salesman, and Charles E.Poirier, notary, the latter two of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and operate a business dealing in heating, air-conditioning and refrigeration appliances or systems, under the name of \"La Cie de Chauffage Pierrefonds Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 15720, Boulevard Gouin, West, Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11159-56) La Compagnie des Maisons Modèles Limitée Model Housing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of April 1956, incorporating: Jérôme Venne, plumber, Ovila Venne, carpenter, both of Hull, and Lionel Tremblay, carpenter, of Masson, all of the judicial district of Hull, for the following purposes : To carry on the operations of a construction company, under the name of \"La Compagnie des Maisons Modèles Limitée \u2014 Model Housing Company Limited\", with a total capital stock of $25,000,.divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Hull, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of April 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General. 1960 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 2S (P.G.11009-50) La Corporation de l'Hôpital du Comté de Chambly Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Salctte, industriel, Arthur Tardif, médecin, tous deux de Montréal-Sud, Edouard-Henri Letellicr, médecin, de Lon-gueuil, Sidney W.Brake, et J.-Hcrvé Martel, industriels, de Saint-Lambert, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir, organiser, développer et administrer un hôpital, sous le nom de \"La Corporation de l'Hôpital du Comté de Chambly\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de S5.000.000.Le siège social de la corporation sera à Lon-gucuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11077-56) Lakeshore Power Shovels Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1956, constituant en corporation: Irwin S.Brodie, Cyril E.Schwisberg et Samuel Greenblatt, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce ou le négoce de machinerie moteurs, bouilloires, béliers mécaniques, outillages pour unité d'énergie et outillage industriel, sous le nom de \"Lake-shore Power Shovels Ltd.\", avec un capital total de S20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 1,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 18 chemin Lakeshore, Beaconsfield, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11106-56) La Laiterie Richelieu Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1956, constituant en corporation: Stanley Foisy, marchand, Berthc Lcbeau, comptable, et Bernard Lebeau, technicien, tous de Saint-Jean, district judiciaire d'iberville, pour les objets suivants: Exercer le commerce du lait, et des produits et sous-produits du lait, sous le nom de \"La Laiterie Richelieu Ltée\", avec un capital total de $69,900, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 199 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'iberville.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(A.G.11009-56) La Corporation de l'Hôpital du Comté de Chambly Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eith-teenth day of April, 1956 to incorporate as a corporation without share capital: Marcel Salette, industrialist, Arthur Tardif, physician, both of Montreal-South, Edouard-Henri Lettellier, physician, of Longueuil, Sidney W.Brake, and J.Hervé Martel, industrialists, of Saint-Lambert, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To establish, organize, develop and administrate a hospital, under the name of \"La Corporation de l'Hôpital du Comté de Chambly\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 85.000,000.The head office of the corporation will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11077-50) Lakeshore Power Shovels Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1956, incorporating: Irwin S.Brodie, Cyril E.Schwisberg and Samuel Greenblatt, advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in and with machinery, engines, boilers, bulldozers, power plant equipment and industrial equipment, under the name of \"Lakeshore Power Shovels Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 18 Lakeshore Road, Beaconsfield, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11106-56) La Laiterie Richelieu Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1956, incorporating: Stanley Foisy, merchant, Berthe Lcbeau, accountant, and Bernard Lebeau, technician, all of Saint John, judicial district of Iberville, for the following purposes: To deal in dairy products and the by-products thereof, under the name of \"La Laiterie Richelieu Ltée\", with a total capital stock of 869,900, divided into 500 common shares of $100 each and 199 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint John, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.183 1967 (P.G.11102-56) La Quincaillerie Gérard Raymond Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixii des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Gérard Raymond, Gaétan Lavoie, Guy Lavoie, marchands, de Saintc-Genevièvc-dc-Pierrefonds, et Charles E.Poirier, notaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour, les objets suivants: Exercer le commerce de quincaillerie, sous le nom de \"La Quincaillerie Gérard Raymond Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15720 RI.Gouin, ouest, Saintc-Gencvièvc-dc-Pierre-fonds, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.11146-56) La Roche Marketing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de^la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1956, constituant en corporation: Jean-Marie LaRochc, vendeur, Cécile Renaud, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jean-Marie LaRochc, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Rolland Langlois, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'huiles et autres produits de lubrification, sous le nom de \"La Roche Marketing Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5103, me St-André, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11305-50) L'Association des Marchands et Réchapeurs de Pneus de Québec Inc.Quebec Tire Dealers and Retreadcrs Association Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Russell A.Armitagc, Joseph H.Asselin, Frank R.Mills, administrateurs, de Ville Mont-Royal, Roger D.Boucher, Samuel S.Albert, administrateurs, Jean C.Bherer, avocat, de Montréal, et Joseph V.Butler, administrateur, de Laval-des-Rapides, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Grouper en association les personnes qui s'occupent de la vente ou de la réparation ou entretien des pneus ou de produits connexes, sous le nom de \"L'Association des Marchands et Réchapeurs de Pneus de Québec Inc.\u2014 Quebec Tire dealers and Retreaders Association Inc.\".(A.G.11102-50) La Quincaillerie Gérard Raymond Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April 1956, incorporating: Gérard Raymond, Gaétan Lavoie, Guy Lavoie, merchants of Saint Geneviève de Pierrefonds, and Charles E.Poirier, notary, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in hardware, under the name of \"La Quincaillerie Gérard Raymond Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at 15720 Bl.Gouin, West, Saint Geneviève de Pierrefonds, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April 1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11140-56) La Roche Marketing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1956, incorporating: Jean-Marie LaRochc, salesman, Cécile Renaud, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean-Marie LaRochc, and duly authorized by him for these present purposes, and Rolland Langlois, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for\"the following purposes: To operate a business dealing in oils and other products of lubrication, under the name of \"La Roche Marketing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at 5163, St.André Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11365-56) L'Association des Marchands et Réchapeurs de Pneus de Québec Inc.Quebec Tire Dealers and Retreaders Association Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1956 to incorporate as a corporation without share capital: Russell A.Armitage, Joseph II.Asselin, Frank R.Mills, administrators, of the town of Mount Royal, Roger D.Boucher, Samuel S.Albert, administrators, Jean C.Bhérer, advocate, of Montreal, and Joseph V.Butler, administrator, of Laval-des-Rapides, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To group into an association persons who deal in the sale or repairs or maintenance of tires or products pertaining thereto, under the name of \"L'Association des Marchands et Réchapeurs de Pneus de Québec Inc.\u2014 Quebec Tire Dealers and Retreaders Association Inc.\". 1968 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° S3 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 820.000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1956.L'Assistant -procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11093-56) Lea wood Camp Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1956, constituant en corporation: Jules Leavitt, administrateur de camp, Sol Sidney Fels et Bernard Gardner, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'un camp, sous le nom de \"Lcawood Camp Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 5 actions ordinaires de 8100 chacune et 195 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à l'Annonciation, district judiciaire de Labelle.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11008-56) Le Comité d'Expansion Industrielle de la Ville de Nicolet Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze avril 1956, constituant en corporation sans capital-actions: J.-Alphonse Martin, industriel, Henri-Paul Ricard, agronome, et Georges Robin, marchand, tous des cité et district judiciaire de Nicolet, pour les objets suivants: Promouvoir, protéger et développer le commerce et l'industrie dans les limites de la ville de Nicolet, sous le nom de \"Le Comité d'Expansion Industrielle de la Ville de Nicolet\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de S20.000.Le siège social de la corporation sera à Nicolet, district judiciaire de Nicolet.Daté du bureau du Procureur général, le douze avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11045-56) Les Oblatcs Missionnaires de l'Immaculée Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Luce Lacombe, Annette Trudeau et Annette Dion, infirmières diplômées, filles majeures, toutes de Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Poursuivre des oeuvres missionnaires, sociales, religieuses, d'hospitalisation, d'éducation, de cha- The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 820,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11093-56) Lea wood Camp Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1956, incorporating: Jules Leavitt, camp operator, Sol Sidney Fels and Bernard Gardner, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate the business of a camp, under the name of \"Leawood Camp Inc.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 5 common shares of $100 each and into 195 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at L'Annonciation, judicial district of Labelle.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11008-56) Le Comité d'Expansion Industrielle de la Ville de Nicolet S Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of April, 1956 to incorporate as a corporation without share capital: J.Alphonse Martin, industrialist, Henri-Paul Ricard, agronomist, and Georges Robin, merchant, all of the city and judicial district of Nicolet, for the following purposes: To promote, protect and develop business and industry within the limits of the town of Nicolet, under the name of \"Le Comité d'Expansion Industrielle de la Ville de Nicolet\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation \u2022 may hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at Nicolet, judicial district of Nicolet.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11045-56) Lea Oblatcs Missionnaires de l'Immaculée Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Luce Lacombe, Annette Trudeau and Annette Dion, graduate nurses, spinsters all of Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry out missionary, social, religious work, as well as hospitalization, educational, charitable QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 1969 rite et de bien-être social, sous le nom de \"Les Oblates Missionnaires de l'Immaculée\".Le revenu annuel maximum des immeubles que la corporation pourra posséder pour des fins de revenus, est limités à $200,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11023-56) Lester Originals Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation : Lester Dick, manufacturier, Ignaz Golman, comptable, Ruth Dick, ménagère, épouse séparée de biens de Lester Dick et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, de Montréal, et Arthur Yanofsky, avocat, de Ville St-Laurent, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles vestimentaires et textiles, sous le nom de \"Lester Originals Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10885-56) Maritime Realties Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1956, constituant en corporation: Mander Rafuse, courtier d'immeubles, Florence Josephine Rafuse, épouse séparée de biens de Mander Rafuse, Gunars Pokuls, gérant de ventes, de Beaconsfield et J.Beaudoin Hand-field, avocat, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de terrains, sous le nom de \"Maritime Realties Incorporated\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10829-56) Métropole Auto Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq avril 1956, constituant en corporation: J.-Marcel Leclair, courtier en assurance, Jacqueline Laurendeau, secrétaire, célibataire, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, et and social welfare work, under the name of \"Les Oblates Missionnaires de l'Immaculée\".The maximum annual revenue of the immovables which the corporation may hold is to be limited, is limited to $200,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11023-56) Lester Originals Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1956, incorporating: Lester Dick, manufacturer, Ignaz Goldman, accountant, Ruth Dick, housewife, wife separate as to property of Lester Dick, and duly authorized by him for the purpose of these presents, of Montreal, and Arthur Yanofsky, advocate, of the town of St.Laurent, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and textiles, under the name of \"Lester Originals Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1950.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10885-56) Maritime Realties Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: Mander Rafuse, real estate broker, Florence Josephine Rafuse, wife separate as to property of Mander Rafuse, Gunars Pokuls, sales manager, of Beaconsfield, and J.Beaudoin Handfield, lawyer, of West-mount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate and land company, under the name of \"Maritime Realties Incorporated\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 common shares of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10829-56) Métropole Auto Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April, 1956, incorporating: J.Marcel Leclair, insurance broker, Jacqueline Laurendeau, secretary, bachelor, both of the city and judicial district of Montreal, and Marcel Landry, advocate, of \" 1970 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 Marcel Landry, avocat, de Beloeil, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Former un club pour protéger les intérêts des propriétaires de véhicules automobiles et exploiter un garage à ces fins, sous le nom de \"Métropole Auto Club Inc.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 200 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.C.11075-50) Mitchell Industries Ltd.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi ces compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq avril 1950, constituant en corporation: John L.Libcrman, Irving L.Adessky et Moses Moscovitch.tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de menus articles et effets fabriqués de verre, bois, fer, cuivre, plomb, zinc, aluminium, acier, nickel et autres métaux ou substances de toute composition ou compositions d'iceux, sous le nom de \"Mitchell Industries Ltd.\".avec un capital total de 810,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI 00 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11098-56) Modem Office Methods Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: Marcus Meyer Spcrber, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Alan Bernard Gold, avocat, de Montréal et Murray Lapin, avocat, de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger un commerce général de tenue de livres, sous le nom de \"Modern Office Methods Corp.\", avec un capital total de SI .000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9025 Avenue du Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11041-56) ' Monastra Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: David Goodman, avocat, de Hampstead, Neil Phillips, Melvin Rothman, avocats, de Westmount et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille Bclœil.judicial district of Richelieu, for the following purposes: To form a club to protect the interests of motor vehicles owners and to operate a garage for such purposes, under the name of \"Métropole Auto Club Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head oflice of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11070-56) Mitchell Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Govrenor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April, 1956, incorporating: John L.Liberman, Irving L.Adessky and Moses Moscovitch, all Advocates, of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wares and articles of glass, wood, iron, brass, lead, zinc, aluminum, steel, nickel or other metals or materials or any combination or combinations thereof, under the name of \"Mitchell Industries Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 50 common shares of the par value of SI 00 each and into 350 preferred shares of the par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of April, 1950.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11098-50) Modern Office Methods Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Marcus Meyer Sper-ber, advocate and Queen's Counsel, of West-mount, Alan Bernard Gold, advocate, of Montreal, and Murray Lapin, advocate, of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To establish, maintain and conduct a general book-keeping business, under the name of \"Modern Office Methods Corp.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 100 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at 9025 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1950.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11041-56) Monastra Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the Sixth day of April, 1956, incorporating: David Goodman, advocate, of Hampstead, Neil Phillips, Melvin Rothman, advocates, of Westmount, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, oPMontreal, all QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.28 1971 majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: A des fins de placements, acquérir une certaine propriété immobilière et agir comme bailleurs et administrateurs relativement à icelle, sous le nom de \"Monastra Enterprises Ltd.\", avec un capital total de §1,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10941-56) Montreal Offset Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1956, constituant en corporation: Gisèle Delormc, marchande publique, épouse séparée de biens de Claude Brunette, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Adrien R.Paquctte, avocat, et Françoise Frégcau, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimerie, sous le nom de \"Montreal Offset Ltd.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 100 communes de S100 chacune et en 100 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11074-56) Mt-Royal Greeting Cards Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1956, constituant en corporation: Paul Galt Michaud, Gilles Denis et Jacques Cantin, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, distribuer et faire le commerce de gravures, impressions, images, dessins et toutes reproductions et cartes de fête ou de souhaits écrites, gravées, peintes ou imprimées, sous le nom de \"Mt-Royal Greeting Cards Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10866-56) National Glass Co.Lid.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1956.constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, Harriet Beutel, teneuse de livres, tous deux de Westmount et of the judicial district of Montreal, for the following purposes: For the purpose of investment, to acquire a certain immoveable property and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Monastra Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 common shares of 81 each.The head office of the company will be at.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genccral, this sixth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10941-56) Montreal Offset Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Gisèle Delorme, public merchant, wife separate as to property of Claude Brunette, and duly authorized by him for the purposes therein, Adrien R.Paquette, advocate, and Françoise Frégcau, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of printing, under the name of \"Montreal Offset Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 100 common shares of 8100 each and 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11074-56) Mt-Royal Greeting Cards Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: Paul Gait Michaud, Gilles Denis and Jacques Cantin, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, distribute and deal in engraving, prints, pictures, drawings and any written, engraved, painted or printed productions and seasonal and greeting cards, under the name of \"Mt-Royal Greeting Cards Ltd.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 200 common shares of the par value of §100 each and into 300 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10S66-56) National Glass Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, Harriet Beutel, book-keeper, both of Westmount, and Joseph R.Hoffman, advocate, 1972 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1966, Tome 88, N° S3 Joseph R.Hoffman, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de verre et tous procédés y connexes, sous le nom de \"National Glass Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540 P.FRENETTE.(P.G.10953-50) National Turpentine Inc.Nationale Térébenthine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Lucien Leroux, industriel, Jean-Marie Nadeau, avocat, et Louis Couard, agent commercial, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de peintures, polis et enduits, produits chimiques, matériaux à nettoyer ou à assurer l'étanchéité, sous le nom de \"National Turpentine Inc.\u2014 Nationale Térébenthine Inc.\", avec un capital-actions divisé en 10 actions sans valeur au pair et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11097-56) Parisian Gardens Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Harry Brumer, Leon Kondol et Harry Finkels-tein, tous marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objtes suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Parisian Gardens Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2430 nie Mantha, ville St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11043-50) Permanent Furniture Showroom Ltd.Exposition Permanente du Meuble Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1950, constituant en corporation: Albert Matte, Gilbert Matte, vendeurs, Saul Levenson, manufeaturier, de Montréal, et René of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers in glass and all processes in connection therewith, under the name of \"National Glass Co.Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1950.P.FRENETTE, 42510-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10953-50) National Turpentine Inc.Nationale Térébenthine Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1950, incorporating: Lucien Leroux, industrialist, Jean-Marie Nadeau, advocate, and Louis Collard, commercial agent, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in paints, polishes and glazes, chemical products, materials for cleansing or to insure against leakage, under the name of \"National Turpentine Inc.\u2014 Nationale Térébenthine Inc.\", with a capital stock divided into 10 no par shares and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11097-56) Parisian Gardens Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, incorporating: .Tarry Brumer, Leon Kondol and Harry Finkelstein, all merchants, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Parisian Gardens Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 50 common shares of a par value of $100 each and into 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 2430 Mantha Street, ville St.Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11043-56) Permanent Furniture Showroom Ltd.Exposition Permanente du Meuble Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Prlvince of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1956, incorporating: Albert Matte, Gilbert Matte, Salesmen, Saul Levenson, manufacturer, of Montreal, and René Pufour, Salesman, of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1966, Vol 88, No.23 1973 Dufour, vendeur, de Dorval, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de meubles et nouveautés d'iceux, sous le nom de \"Permanent Furniture Showroom Ltd.\u2014Exposition Permanente du Meuble Ltée\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11017-56) P.IL Savard Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation : Paul-H.Savard, cultivateur et entrepreneur général, de Rang Saint-Joseph, Saint-Fulgence, J.-P.-E.Savard, comptable, et André Morin, avocat, ces deux derniers de Chicoutimi, tous du district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneur général, sous le nom de \"P.H.Savard Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions de $40 chacune.Le siège social de la compagnie sera Rang Saint-Joseph, Saint-Fulgence, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11030-56) Primo Realty Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Rriskin, avocats, Pauline Sherman, fille majeure, secrétaire, et Amie McNamee, fille majeure, gérante de bureau, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains et intérêts en iccux; ériger ries bâtisses et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Primo Realty Inc.\", avec un capital-actions divisé en 1 ;000 actions sans valeur nominale ou au pair et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540 P.FRENETTE.(P.G.10894-56) Ramesay Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq avril 1956.constituant en corporation: Philippe Morello', entrepreneur, Raphaël Espo- Dorval, all of the judicial disttict of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture and furniture novelties, under the name of \"Permanent Furniture Showroom Ltd.\u2014Exposition Permanente du Meuble Ltée\", with a capital stock divided into 1,000 common shares having no nominal or par value and into 450 preferred shares of;$100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11017-56) P.H.Savard Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1956, incorporating: Paul Savard, farmer and general contractor, of Range Saint Joseph, Saint Fulgence, J.-P.-E.Savard, accountant, and André Morin, advocate, the two latter of Chicoutimi, all of the judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on business as general contractor, under the name of \"P.II.Savard Ltcc\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 shares of $40 each.The head office of the company will be at Range Saint Joseph, Saint Fulgence, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, \" this fourth day of April.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11030-56) Primo Realty Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1956, incorporating: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Briskin, advocates, Pauline Sherman, of the age of majority, secretary, and Annie McNamce, of the age of majority, office manager, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire lands and interests therein; to erect buildings and deal in building materials, under the name of \"Primo Realty Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 shares having no nominal or par value and into 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of.ihe company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10894-56) Ramesay Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of April 1956, incorporating: Philippe Morello, contractor, Raphaël Esposito, notary, Henri M. 1974 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 sito, notaire, Henri M.Bcaulieu, commerçant, Mario Béaulieu, notaire stagiaire, Tony Capo-bianco, agent d'assurance, de Montréal, et René Thomas, comptable, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructions et d'entrepreneurs généraux) sous le nom de \"Ramesay Inc.\", avec un capital total de Si 2,000, divisé en 120 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 0700, rue Drolet, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.10938-56) Raymond Bergeron Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1956, constituant en corporation: Raymond Bergeron, marchand, Rita B.Bergeron, ménagère, célibataire, tous deux de Sherbrooke, et Arthur Bernicr, commis, de Bromptonville, tous du district judiciaire de Saint-François, poulies objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles, jouets, accessoires mécaniques et électriques, sous le nom de \"Raymond Bergeron Limitée\", avec un capital total de 810,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Bromptonville, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.12044-56) Rcdler Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corporation: Kenneth Hughes, ingénieur, Harry Pinker, avocat, et Rose Pinker, ménagère, épouse séparée de biens dudit Harry Pinker, et d liment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce d'entrepreneur électricien, manufacturer et exercer le commerce d'articles et accessoires électriques, sous le nom de \"Rcdler Electric Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, 5549 avenue Glen Crest Côte St-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.Bcaulieu, merchant, Mario Bcaulieu, notarial clerk, Tony Capobianco, insurance agent, of Montreal, and René Thomas, accountant, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of builders and general contractors, under the name of \"Ramesay Inc.\", with a total capital stock of 812,000, divided into 120 shares of SI00 each.The head office of the company will be at 0700 Drolet Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of April 1950.P.FRENETTE, 42510 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10938-56) Raymond Bergeron Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1956, incorporating: Raymond Bergeron, merchant, Rita B.Bergeron, housewife, bachelor, both of Sherbrooke, and Arthur Bernier, clerk, of Bromptonville, all of the judicial district of Saint-Francis, for the following purposes : To carry on an industry and business dealing in furnitures, toys, mechanical and.electrical accessories, under the name of \"Raymond Bergeron Limitée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Bromptonville, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12044-56) Rcdler Electric Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1955, incorporating: Kenneth Hughes, engineer, Harry Pinker, advocate, and Rose Pinker, housewife, wife separate as to property of the said Harry Pinker, and duly authorized by him for the purposes of these presents, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate an electrical contracting business; to manufacture and deal in electrical wares and supplies, under the name of \"Rcdler Electric Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of SI each and into 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at 5549 Glen Crest Ave, Cote St.Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1955.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol 88, No.23 1975 (P.G.11176-56) Red Mount Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize avril 1956, constituant en corporation: Jean LeBret, administrateur et prospecteur de mines, de la ville de St-Siméon, district judiciaire de Saguenay, Harold Wine, étudiant, en droit d'Outremont, et Samuel J.Smiley, avocat, de Montréal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Red Mount Chibougamau Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de §5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(A.G.11170-56) Red Mount Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of April, 1956, incorporating: Jean LeBret, mine executive and prospector, of the town of St.Simeon, judicial district of Saguenay, Harold Wine, law student, of Outre-mont, and Samuel J.Smiley, advocate, of Montreal, of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Red Mount Chibougamau Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 85,000,000, divided into 5,000,000 shares of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11145-56) Rcnoco Inc.(A.G.11145-56) Rcnoco Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1956.constituant en corporation: Jean-Marie LaRoche, vendeur, Cécile Renaud, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jean-Marie LaRoche, et dûment au-trisée par lui aux fins des présentes, et Rolland Langlois, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'accessoires d'automobiles, sous le nom de \"Rcnoco Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8981, rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11138-56) Rex Chibougamau Minet, Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze avril 1956, constituant en corporation: Raymond Leboeuf, avocat, Maurice de Bèllefeuille, courtier et Êphraim Leboeuf, C.R., avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: .Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Rex Chibougamau Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de 85,000,000 divisé en 5,000.000 d'actions de §1 chacune.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April 1950, incorporating: Jean-Marie LaRoche, salesman, Cécile Renaud, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean-Marie LaRoche, and duly authorized by him for the purposes therein, and Rolland Langlois, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of automobile accessories, under the name of \"Rcnoco Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company will be at 8981 Lajeunesse Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of April 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11138-56) Rex Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of April, 1956, incorporating: Raymond Leboeuf, lawyer, Maurice de Bèllefeuille, broker, and Êphraim Leboeuf, Q.C., lawyer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Rex Chibougamau Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of S5,000,000, divided into 5,000,000 shares of 81 each. 1976 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 28 Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42510 P.FRENETTE.(P.G.11059-50) Rivermoiit Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956.constituant en corporation: Simon Lavcrdière, avocat, Fabiola Bouchard, sténographe, célibataire, tous deux de Québec, et Louis Fortin, avocat, de Sainte-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"River-mont Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $99,900.divisé en 999 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Sophie, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.10996-56) Roland Frenetic Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été .accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1956, constituant en corporation: Contran Daoust, comptable, de Saint-Vincent-de-Paul.Olivette Payette, et Aline Normandeau, secrétaires, filles majeures usant de leurs droits, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur général et agent et vendeur d'immeubles, sous le nom de \"Roland Frenette Ltée\", avec un capital total de $100,000.divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mars 1956.L'Assistai)t-procureu r généra I suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.11021-56) Ruco Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la I.oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation: Isidore M.Bobrove, Jack B.Bobrove.et Samuel Shriar, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et développer des emplacements irur.mobiliers, sous le nom de \"Ruco Enterprises Inc.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attoreny General, this twelfth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11059-50) Rivcrmont Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1950, incorporating: Simon Laver-dière, advocate, Fabiola Bouchard, stenographer, spinster, both of Quebec, and Louis Fortin, advocate, of Saint Foy, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the businessof builders and general contractors, under the name of \"RiVermont Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $99,900, divided into 999 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint Sophie, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10996-56) Roland Frenetic Liée Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1956, incorporating: Contran Daoust, accountant, of Saint-Vincent-de-Paul, Olivette Payette and Aline Normandeau, secretaries, of full age and in use of their rights, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a business as general contractor and agent and real estate salesman, under the name of \"Roland Frenette Ltée\", with a total capital stock of $100.000.divided into 250 common shares of a par value of $100 each and into 750 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of March.1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11021-56) Ruco Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1956, incorporating: Isidore M.Bobrove, Jack B.Bobrove and Samuel Shriar.all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and develop immoveable emplacements, under the name of \"Ruco Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th.1956, Vol.88, No.23 1977 $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11079-56) Schwartz Investments Corp.Avis est donné qu'nc vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1956, constituant en corporation: Joseph Roy Hoffman, avocat, de Montréal, Harriet Bcutel, teneuse de livres, de Westmount, et Oscar Rcspitz, avocat, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des propriétés immobilières, et tous biens fonciers ou intérêts en iceux, sous le nom de \"Schwartz Investments Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11036-56) Ste-Thérèsc Brique et Pierre Cie Ltée (Ste.Thérèse Stone and Brick Co.Ltd.) Avis est donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation: Paul Larosc, avocat, de Sainte-Thérèse, Pierrette Moquin, secrétaire, célibataire, et Vital Mous-seau, comptable, ces deux derniers de Saint-Jérôme, tous du district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction et le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Ste-Thérèse Brique et Pierre Cie Ltée \u2014 (Ste.Thérèse Stone and Brick Co.Ltd.), avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Thérèse-de-BIainvillc, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1950.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11079-50) Schwartz Investments Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1956, incorporating: Joseph Roy Hoffman, advocate, of Montreal, Harriet Beutel.book-keeper, of Westmount.and Oscar Respitz, advocate, of the Town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire immoveable properties and any estate or interest therein, under the name of \"Schwartz Investments Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11036-56) Ste-Thérèsc Brique et Pierre Cie Ltée (Ste.Thérèse Stone and Brick Co.Ltd.) Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1956, incorporating: Paul Larose, advocate, of Saint Thérèse, Pierrette Moquin, secretary, spinster, and Vital Mousseau, accountant, the two latter of Saint Jérôme, all of the judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the operations of a construction company and \"deal in building materials, under the name of \"Ste-Thérèsc Brique et Pierre Cie Ltée \u2014 (Ste.Thérèse Stone and Brick Co.Ltd.)\".with a total capital of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint Thérèse-de-Blainvilie, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10988-56) St-Georges Excavation |*j Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1956, constituant en corporation: Jean-Paul St-Georgcs, opérateur de pelle mécanique, de Fort Chambly, Roland Jarry, courtier en immeubles, de Sainte-Dorothée, et L.René Hamelin, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: (A.G-10988-50) St-Georges Excavation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1950.incorporating: Jean-Paul St.Georges, operator for mechanical shovel, of Fort Chambly, Roland Jarry.real estate broker, of Sainte-Dorothée, and L.René Hamelin.advocate, of Montreal, all of the judicil district of Montreal, for the following purposes: 1978 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 Exercer le commerce d'entrepreneur général en excavation, sous le nom de \"St-Georges Excavation j'j^j6 ' avec un capital total de 899.000, divisé en 400 actions communes de $100 chacune et en 590 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Dorothée, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1950.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o P.FRENETTE.(P.G.11117-50) St-Maurlcc Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze avril 1950.constituant en corporation: John H.Keenan, ingénieur, de La Tuque, district judiciaire de Québec, .!.-('lande Panneton, vendeur, de Cap-de-la-Madeleine, et Conrad Mat-teau, notaire, de Shawinigan-Sud, ces deux derniers du district judiciaire de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'électricien, fabriquer et installer des appareils et accessoires électriques, sous le nom de \"St-Maurice Electric Inc.\"; avec un capital total de 810,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Tuque, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze avril 1950.L'Assistant -procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.10887-50) Syndicat Granbien Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1950, constituant en corporation: Lise Beaudoin, Thérèse Scott, secrétaires, filles majeures, et Gérard Cazeault, agent d'assurance, tous de Granby, district judiciaire de Red-ford, pour les objets suivants: Acheter, vendre et échanger des fonds de commerce de toute nature en tout ou en partie, des lettres de change quelconques, effets de commerce, créances hypothécaires ou privilèges immobiliers, comptes recevables ou autres, et exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Syndicat Granbien Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions communes de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Befdord.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mars 1050.L'Assistant-procureur général suppléant.42540-o I'.FRENETTE.(P.G.11042-50) The .IcfTVina Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six avril 1950, constituant en corporation: Louis IL Rohrlick, C.R., avocat, Paul L.Gordon avocat, Thelma Goldstein et Joyce Pilzmacker, filles majeures, secrétaires, tous des cité et To carry on a business as general contractor in excavation, under the name of \"St-Georges Excavation ' with a total capital stock of $99,000, divided into 400 common shares of 8100 each and into 590 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Sainte-Dorothée, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11117-50) St-Mauricc Electric Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April 1950, incorporating: John R.Keenan, engineer, of La Tuque, judicial district of Quebec, J.-Claude Panneton, salesman, of Cap de la Madeleine, and Conrad Maltcau.notary, of Shawinigan-South, the two latter of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on the business of electrician, to manufacture and install electrical apparatus and appliances, under the name of \"St.Maurice Electric Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at La Tuque, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April 1950.P.FRENETTE.42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10887-50) Syndicat Granbien Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1950, incorporating: Lise Reaudoin, Thérèse, Scott, secretaries, of full age, ami Gérard Cazeault, insurance agent, all of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To buy.sell and exchange business of any nature in whole or in part, bills of exchange of any kind, trade acceptance, or mortgagees or real estate privileges, accounts receivable or others, and to carry on a real estate business under the name of \"Syndicat Granbien Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-ninth dav of March.1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11042-56) The Jeffrina Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1950, incorporating: Louis II.Rohrlick, Q.C., advocate, Paul L.Gordon, advocate, Thelma Goldstein and Joyce Pilzmacker, spinsters, of the full age of majority, secretaries, all of '1 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 1979 district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"The Jeffrina Investment Corp.\", avec un capital total de $250,000, divisé en 40 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $500 chacune, 2,200 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $100 chacune et 20 actions ordinaires d'une valoir au pair de $500 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.10090-50) Trailer Equipment Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril, 1950, constituant en corporation: J.Austin Murphy, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Pierre Décary, avocat et Francis J.Dolan, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'accessoires de roulottes et pièces de toutes sortes de machinerie, sous le nom de \"Trailer Equipment Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 125 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 375 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540 P.FRENETTE.(P.G.11112-50) \u201e Verdun Ornamental Iron Works Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec ties lettres patentes, en date du neuf avril 1950, constituant en corporation : Albini Pilon, industriel et commerçant, de Verdun, Jean F.Laureys, avocat, de Westmount, et Palména Pelletier, secrétaire, célibataire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandises et articles faits en tout ou en partie de métaux ou de bois, sous le nom de \"Verdun Ornamental Iron Works Limited\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social de la compagnie sera 1140 rue Hickson, Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.(P.G.11010-56) Wellco Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre avril 1956, constituant en corporation: the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"The Jeffrina Investment Corp.\", with a total capital stock of $250,000, divided into 40 Class \"A\" preferred shares of the par value of $500 each, 2,200 Class \"B\" preferred shares of the par value of $100 each and into 20 common shares of the par value of $500 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office'bf the Attorney General, this sixth day of April, 1950.\" P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10090-50) Trailer Equipment Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: J.Austin Murphy, advocate and Queen's Counsel, Pierre Decary, advocate, and Francis J.Dolan, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in accessories for automobile trailers, and parts of all kinds of machinery, under the name of \"Trailer Equipment Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 125 common shares of a par value of $100 each and into 375 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1956.P, FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11112-56) Verdun Ornamental Iron Works Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1956, incorporating: Albini Pilon, industrialist and dealer, of Verdun, Jean F.Laureys, advocate, of Westmount, and Palména Pelletier, secretary, bachelor, of Montreal, all of the judicial district of Montreal,-for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise and articles made in whole or in part of metal or of wood, under the name of \"Verdun Ornamental Iron Works Limited\", with a capital stock divided into 1,000 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at 1140 Hickson Street, Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11010-56) Wellco Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1956, incorporating: Joseph George 19X0 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 Joseph George Schwartz, comptable.Tillie Abra-movitch, ménagère, épouse séparée de biens de Joseph George Schwartz, et dûment autorisée par ce cernier aux fins des présentes, et William Cheifetz, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de cordage, cables, cordes à ligne, cordes à toiles vénitiennes, ficelle, fils mercerisés, fils, chanvre, lin, galons et cordons, sous le nom de \"Wcllco Corporation\", avec un capital total de S 10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, \u202212510 P.FRENETTE.(P.G.109-15-50) W.Proulx, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mars 1950, constituant en corporation: Amédée Proulx, grossiste, Mariette M a rois Proulx.ménagère, épouse d'Amédée Proulx, et Claude Proulx, gérant, tous de Mont-magny, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants: Faire affaires comme épicier, sous le nom de \"W.Proulx, Inc.\", avec un capital total de S 100,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montmagny, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 42540-o P.FRENETTE.Schwartz, accountant, Tillie Abramovitch, Housewife, wife separate as to property of Joseph (ieorge Schwartz, and duly authorized by him for the purpose of these presents, and William Cheifetz, merchant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in cordage, ropes, clothes line,Venetian cord, twines, threads, yearns, hemp, flax and braided lines and cords, under the name of \"Wellco Corporation\", with a total capital stock of $40.000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1950.P.FRENETTE, 42540-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10945-50) W.Proulx, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of March, 1950, incorporating: Amédée Proulx, wholesaler, Mariette Marois Proulx, housewife, wife of Amédée Proulx, and Claude Proulx, manager, all of Montmagny, judicial district of Montmagny.To carry on business as grocer, under the name of \"W.Proulx, Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montmagny, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of March, 1956.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux travailleurs en fourrure dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 3746 du 17 octobre 1940 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret : 1° Le 5ème alinéa du paragraphe \"q\" de l'article V sera remplacé par le suivant: \"Sujet aux avantages, privilèges, droits et conditions mentionnées dans les deux paragraphes immédiatement précédents, tout salarié, ayant trois ans ou plus de service continu pour le compte d'une même employeur, a droit à une semaine additionnelle de vacances, salaire payé.Cette semaine additionnelle de vacances comprend sept jours consécutifs et doit être donnée au salarié entre le 15 juin et le 15 août de l'année suivante, consécutivement à la 1ère semaine.\" Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the fur workers of the region of Quebec, rendered obligatory by the decree number 3746 of October 17, 1940 and amendments, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: 1.The first paragraph of subsection \"q\" of section V will be replaced by the following: \"Subject to the advantages, privileges, rights and conditions mentioned in the foregoing two paragraphs, any employee with a minimum of three years of continuous service in the employ of the same employer is entitled to an additional week of vacation with pay.Such additional vacation of one week consists of seven consecutive days and must be given to the employee between June 15 and August 15 of the following year, and shall follow the first vacation week.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 1981 2° L'article XII sera remplacé par le suivant: \"XII.Durée du décret: Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeurera en vigueur jusqu'au 1er juin 1957.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 1 er juin de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au ministre du Travail.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 9 juin 1956.42558-0 AVIS DE MODIFICATION Conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), l'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 44 du 14 janvier 1954 et amendements, relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, savoir: Le paragraphe \"c\" suivant sera ajouté à l'article 98: \"c) Il peut y avoir appel au Ministre du Travail de toute décision du Comité paritaire refusant de reconnaître un établissement qui enseigne ou projette d'enseigner les métiers de coiffeur pour hommes ou pour dames ainsi que le métier de manucure-esthéticienne.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-Ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 9 juin 1956.42558-0 AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de l'imprimerie dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret No.141, du 8 février 1951, lui ont présenté une requête pour être soumise à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil aux fins de modifier ledit décret comme suit : \u2022 1° Le paragraphe 4 de l'article III sera remplacé par le suivant: 2.Section XII will be replaced by the following: \"XII.Duration of the decree: The present decree shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and shall remain effective until June 1st, 1957.Ir then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notify the other party, in writting, to the contrary within the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day before June 1st of any subsequent year.Such a notice must also be sent to the Minister of Labour.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set fortn.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, June 9, 1956.42558-o NOTICE OF AMENDMENT Pursuant to the procedure established under section 8 of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), the Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, that he intends to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree number 44 of January 14th, 1954 and amendments, relating to the men's and ladies' hairdressing trades in the district of Quebec, to wit: The following subsection \"c\" will be added to section 98: \"c) Any decision of the Parity Committee refusing to recognize an establishment that teaches or intends to teach the men's or ladies' hairdressing trades or the manicure-eastlietician's trade may be appealed to the Minister of Labour.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister fo Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec, June 9, 1956.42558-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the printing trades in the region of Quebec, rendered obligatory by the decree No.141 of February 8, 1951, have presented to him a petition to be submitted to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council for the purpose of amending the said decree, as follows: 1.Subsection 4 of section III will be replaced by the following: 1982 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° 23 \"4.Classe \"D-A\": La classe \"D-A\" comprend et désigne tous les ateliers possédant au moins une presse à plateau automatique.( lasse \"D-B\": La classe \"D-B\" comprend et désigne tous les ateliers possédant une ou plusieurs presses à plateau mnrgées à la main.\" 2° Les paragraphes \"a\", \"b\" et \"c\" de l'article IV seront remplacés par les suivants: \"IV.Durée du travail: a) Le jour, les heures de travail sont réparties entre 7.00 a.m.et 0.00 p.m.les cinq (5) premiers jours ouvrables de la semaine et entre 7.00 a.m.et midi, le samedi.1.Quarante (40) heures, au maximum, réparties dans les six (0) jours ouvrables, constituent une semaine régulière de travail pour tous les ateliers du district judiciaire de Québec, à l'exception du département des presses à l'aniline des manufactures de sacs en papier et du département d'imprimerie des fabriques de boîte de carton, où la semaine régulière de travail sera la même que celle de la manufacture.2.Huit (8) heures, au maximum, constituent une journée ou une nuit régulière de travail pour tous les ateliers du district judiciaire de Québec, à l'exception du département de presses à l'aniline des manufactures de sacs en papier et du département «l'imprimerie des fabriques de boîte de carton, où les journées de travail maxima sont les mêmes que celles de la manufacture.3.Quarante-quatre heures (44), au maximum, constituent une semaine régulière de travail pour les ateliers des districts judiciaires autres que celui de Québec.Toutefois, il est permis à ces ateliers de faire quatre (4) journées de neuf (9) heures régulières et une (1) journée de huit (8) heures régulières de façon à compléter la semaine de travail en cinq (5) jours.\" \"b) Pour les équipes de nuit, les heures de travail seront réparties entre les heures régulières de la fin et du commencement de l'équipe de jour.Trente-sept (37) heures, au maximum, constituent une semaine régulière de travail de nuit, sauf pour les ateliers des districts judiciaires autres que celui de Québec, où la semaine régulière de nuit est de quarante et une (41) heures, au maximum.\" \"c) Après la journée normale de travail, le temps supplémentaire doit être payé au taux de salaire et demi, à tous les salariés travaillant dans les départements de l'imprimerie des fabriques de boîtes de carton ou sur les presses à l'aniline des manufactures de sacs en papier.\" 3° Dans l'échelle de salaires apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article V, la partie concernant la classe \"D\" sera remplacée par ce qui suit: A compter du \"Classe \"D-A\": 1er sept.1956 Typographe.81.065 Pressier.1.65 \"Classe \"D-B\": Typographe.' 1.55 Pressier.1.55 \" 4° Dans le paragraphe \"d\" de l'article V, la partie concernant la classe \"D\" sera remplacée par ce qui suit: Classe \"D-A\" Classe \"D-B\" A compter du A compter du 1er sept.1956 1er sept.1966 \"1ère année.: 80.60 80.565 2ème année.0.725 0.655 3ème année.0.835 0.74 4ème année.0.935 0.83 5ème année 1er semestre.1.085 0.95 5ème année 2ème semestre.1.26 1.09 \" \"4° Class \"D-A\": Class \"D-A\" includes all shops operating at least one automatic platen press.Class \"D-B\": Class \"D-B\" includes all shops operating one or more hand-fed platen presses.\" 2.Subsections \"a\", \"b\" and \"c\" of section IV will be replaced by the following: \"IV.Duration of labour: a) During the day, the working hours are distributed between 7.00 a.m.and 0.00 p.m., for the first five (5) working days of the week, and between 7.00 a.m.and noon on Saturday.1.A maximum of forty (40) hours distributed among the six (6) working days constituted a standard work week for all the establishments of the judicial district of Quebec, excepting the aniline press department in paper bag factories and the printing department of paper box factories, where the standard work week shall be the same as that of the factory.2.A maximum of eight (8) hours constitutes a standard work day or work night for the establishments of the judicial district of Quebec, excepting the aniline press department in paper bag factories and the printing department of paper box factories, where the maximum work days shall be the same as those of the factory.\" 3.A maximum of forty-four (44) hours constitute a standard work week for the establishments of the judicial districts other than that of Quebec.However, these establishments may work four (4) 9-hour days and one (1) 8-hour day so as to complete the work week in five (5) days.\" \"b) For the night shifts, the hours of work are distributed between the regular starting and finishing hours of the day shift.A maximum of thirty-seven (37) hours constitute a standard night-work week except for the establishments of the judicial districts other then that of Quebec where the maximum standard night-work week consists of forty-one (41) hours.\" \"c) After the regular work day, overtime shall be paid at the rate of time and one half to all employees working in the printing departments of paper box factories or working on aniline presses in paper bag factories.\" 3.In the wage scale appearing in subsection \"a\" of section V, that part concerning class \"D\" will be replaced by the following: From Sept.\"Class \"D-A\": 1st, 1956 Typographer.,____81.665 Pressman.1.65 Class \"D-B\": Typographer.1.55 Pressman.1.55\" 4° In subsection \"d\" of section V, that part concerning class \"D\" will be replaced by the following: Class \"D-A\" Class \"D-B\" From Sept.From Sept.1st, 1956 1st, 1956 \"1st year.$0.60 $0.565 2nd year.0.725 0.655 3rd year.0.835 0.74 4th year.0.935 0.83 5th year: first six months.1.085 0.95 5th year: second six months.1.26 1.09 \" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.23 19S3 5° Duns le paragraphe \"g\" idication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Québec.June 9th.1956.425SX-o Actions en séparation de biens Actions for Separation as to Property Cour supérieure, district d'Arthabaska, N° Superior Court, district of Arthabaska, No.11,542.Dame Alma Giguère, épouse de Armand 11,542.Dame Alma Giguère, wife of Armand Grenier, bourgeois, de Drummondville a formé Grenier, esquire, of Drummondville, has taken contre son mari une action en séparation de biens, action against her husband in separation as to property.Drummondville, le 2 juin 1956.Drummondville, June 2nd 1956.Le Procureur de la demanderesse, PAUL ROUSSEAU, Q.C., 42544-0 PAUL ROUSSEAU, C.R.42544-0 Attorney for the Plaintiff. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, June 9th, 1966, Vol 88, No.23 1987 Canada, province de Québec, district de Ka-niouraska, dans la cour Supérieure, N° 19,807.Daine Odile Jean, tenancière de restaurant, de Nbtrc-Dame-du-Portage, épouse de Sr Jules Léveillé, hôtelier et propriétaire d'un moulin à scie, du même lieu, demanderesse, vs Ledit Jules Léveillé, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 15 mai 1950.Rivière-du-Loup, 29 mai 1950.Le Procureur de la demanderesse, \u202212545-0 D.-E.RIOl'X.Province de Québec, district de Bedford, Cour Supérieure N° 6879.Dame Jeannc-d'Are Picard, épouse de Georges Dalpé, machiniste, dé la cité de Granby, district de Bedford, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Sweetsburg, le 30 mai 1950.Le Procureur de la demanderesse, 42546-0 GEO.-H.DUREAULT, C.R.Canada.Province de Québec, district de Montréal.Cour Supérieure, N° 395638, Procédure Non Sommaire.Dame Mariette Malo, ménagère de Montréal, même district, épouse commune en biens de Mario Daneau, entrepreneur constructeur, des mêmes lieux, demanderesse vs ledit Mario Daneau, entrepreneur constructeur, des mêmes lieux, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 23e jour rie mai L956.Le Procureur de la demanderesse, 42562-o JACQUES BEAUÇHAMP.Canada, Province of Quebec, district of Ka-mouraska, in the Superior Court, No.19,867.Dame Odile Jean, restaurant-keeper, of Notre-Dame-du-Portage, wife of Sr.Jules Léveillé, hotel-keeper and proprietor of a sawmill, of the same place, plaintiff, VS the said Jules Léveillé.defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case on May 15, 1956.Itivière-du-Loup.May 29, 1950.D.-E.RIOUX, 42545 Attorney for Plaintiff.Province of Quebec, district of Bedford No' 6879; Dame Jeanne-d'Arc Picard, wife of George Dalpé.mechanic, of the city of Granby.district of Bedford, has instituted against her husband, an action in separation as to property.Sweetsburg.May 30th.1950.GKO.-IL DUREAULT.Q.C.42546-0 Attorney for Plaintiff.Canada, Province of Quebec, district \u2022 of Montreal.Superior Court, No.395038.Non-Summary Procedure.Dame Mariette Malo.housewife of Montreal, same district, wife common as to property of Mario Daneau, contractor, of the same place, plaintiff, vs the said Mario Daneau.contractor, of the same place, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this case, the 23rd May, 1950.JACQUES BEA I JCHAM P.42562-0 Attorney for the plaintiff.Avis divers Miscellaneous Notices Avis est donné que \"Montclair Boulevard Baptist Church,\" 61, Boulevard Montclair, Hull, province de Québec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour obtenir sa constitution en corporation en vertu de la lxn de la Constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus de la province de Québec 1941 et amendements.Hull, ce vingt-troisième jour de mai, 1956.Les Procureurs de la requérante, DESROSIERS & DESROSIERS, 42480-21-5-o notaires.Notice is hereby given that the \"Montclair Boulevard Baptist Church\", 01, Montclair Boulevard, Hull, Province of Quebec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec, for incorporation under the Church Incorporation Act, chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and Amendments.Hull, this twenty-third dav of Mav, 1950.DESROSIÈRS & DESROSIERS, H notaires, 42480-21-5-o Solicotira for the petitioner.Avis est, par les présentes, donné que l'Assemblée Chrétienne de Shawinigan Palis, dont, les assemblées sont tenues au N° 1894.rue St-Laurent, à Shawinigan Falls, district de Trois-Rivières.s'est adressée au Lieutenant-gouverneur en Conseil pour être incorporée en vertu des dispositions de la Loi de la constitution de certaines églises.Le Procureur des requérants, 42513-22-5-0 ARMAND ROUSSEAU, C.R.(P.G.10988-54) Notre-Dame Construction Lti'e Règlement N° 14 Notice is hereby given that the \"Assemblée Chrétienne de Shawinigan Falls\", whereof the meetings are held at No.1894 St.Laurent Street, at Shawinigan Falls, district of Trois-Rivières, has applied to the Lieutenant-Governor in Council in order to be incorporated in accordance with the provisions of the Church Incorporation Act.ARMANI) ROUSSEAU, Q.C., 42513-22-5 Attorney for petitioners.(A.G.10988-54) Notre-Damf: Construction Ltée Bp-lair No.1J, \"Que le nombre des directeurs de la compagnie \"That the number of the Directors of the soit diminué de huit (8) à trois (3) directeurs\".Company be decreased from eight (8) to three (3) Directors\".Montréal, le 15 mai 1950.Montreal, Mav 15.1950.(Sceau) Le Secrétaire, (Seal) J.-ALFRED ÉTHIER.42559-o J .-ALFRED ÉTHIER.42559 Secrctarv. 1988 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec 9 juin 1956, Tome 88, N° 88 (P.G.10078-55) Lincoln Construction Inc.Règlement concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à cinq: Directeurs: 11.\u2014 Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction composé de cinq (5) directeurs, chacun desquels lors de son élection et pendant toute la durée de son terme devra être détenteur d'au moins une action de la compagnie et avoir payé tout versement exigible sur icelle.Vraie copie Le Secrétaire.42547-o MARCEL BOISVERT.Avis est, par les présentes, donné que le Rév.Donald ('.Merrett, pasteur, de Dalesville,Albert Dixon, fermier, de Brownsburg, George Lawson, fermier, «le Brownsburg et Keith Morrison, fermier et camionneur, de Dalesville Baptist Chruch, présenteront une requête au Lieutenant-gouverneur pour la constitution de leur groupement religieux, en vertu de la Loi de la constitution de certaines églises (S.R.1941, chap.31 I) de la province de Québec.Le Clerc d'Eglise.42556-23-5 M Ile M.KEN N El )V.(P.G.1788-49) Terreau & Racine Limitée Règlement ;Y° ; \"I.Que les affaires dé la compagnie seront administrées par un bureau de direction composé «le sept actionnaires dûment qualifiés au lieu de six.\" 2.Quatre directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau «le direction.\" Certifié vraie copie «lu règlement N°4 approuvé à une assemblée du bureau de direction de Terreau & Racine Limitée, tenue le 29 mars 1950 et dûment approuvé et ratifié par le vote unanime des actionnaires présents à une assemblée générale spéciale conviquée à celte fin, tenue le 15 mai 1950.Québec, le 18 mai 1956.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 42îî60-o ALFRED TERREAU.c (P.G.11175-54) Consolidated Construction Ltd.Extrait des minutes d'une assemblée des directeurs tenue au bureau «le la compagnie, le 1er septembre 1955, et confirmé à l'unanimité à une assemblée des actionnaires le 2 septembre 1955: \u2022 \"Règlement N° 88: Que le nombre de directeurs soit augmenté de trois (3) à quatre (4) qui seront: Un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.\" Vraie copie.42582 (signé) IRVING R.RANSEN.Avis «le rachat partiel Les commissaires d'Ecoles i>our la municipalité de IiA cité de DrUMMONDville (Comté «le Drummond) Émission de $345,000 à 3^-3%, portant la date du 1er août 1954 et échéant en séries (A.G.10078-55) Lincoln construction Inc.By-Law concerning the increasing of the number of directors from three to five: Directors: 11.\u2014 The affairs of the company shall be managed by a Board of Directors composed of five (5) directors, each one of whom at the time «>f his election or during his term of office shall be the holder of at least one of the Company's shares, and shall have paid any payment due on said share.True Copy MARCEL BOISVERT, 12547 Secretary.Public no! ice is hereby given that the Rev.Donald C.Merrett of Dalesville.Pastor; Albert Dixon, farmer of Brownsburg; George Lawson, farmer of Brownsburg: and Keith Morrison, farmer and trucker of Dalesville.all three trustees of the Dalesville Baptist Church, shall petition the Lieutenant-Governor for the incorporation of their religious congregation, under the Church Incorporation Act (R.S.1941.ch.311) r the Province of Quebec.Miss M.KENNEDY, 42556-23-5-0 Church Clerk.(A.G.4788-49) Terreau & Racine Limitée l'y-Lair No./ \"1.That the affairs of the company shall be administrated by a Board of Directors composed of seven duly qualified shareholders, instead of six.\" 2.Four Directors shall form quorum at any meeting «>f the Board of Directors.\" Certified true copy of by-law No.4 approved at a meeting of the Board of Directors of Terreau & Racine Limitée, held on March 29, 1950, and duly approved and ratified by the unanimous vote «)f the shareholders present at a special general meeting oonvocatoer 1st, 1955.and confirmed unanimously at a meeting a shareholders on September 2n«I 1955: \"By-law No 22: That the number of Directors be increase*! from three (3) to four (4) and that thr said «lireetors shall consist of a President, a Vice-President, a Secretary and a Treasurer.\" True Copy.42582-q (Signed) IRVING R.RANSEN.Notice of Partial Redemption The School Commissioners for the Munici-\u2022 i'ality of the city of drummondville (County of Drummond) An issue of $.345.000 at 3>é-3%, bearing «late August 1st, 1954, and maturing serially up to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.June 9th, 1956, Vol 88, No.28 1989 jusqu'au 1er août 1969 (résolutions d'emprunt en date du 3 décembre 1953 et du 23 février 1954).Avis publie est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Drummondville, comté de Drummond, rachèteront par anticipation, au pair, le 1er août 1956, en vertu d'une clause de rachat insérée dans lesdites résolutions d'emprunt, et reproduite sur les obligations, les obligations suivantes: 8 x 81,000 Nos M-328, 329, 330, 331.332.333.334 et 335 du 1er août 1969; et 1 x 8500 No.D-3 du 1er août 1900.Lesdites obligations deviendront dues et payables et elles seront payables et rachetées, principal et intérêt, à la date ci-dessus mentionnée, en monnaie légale du Canada, avec intérêt couru jusqu'au 1er août 1950, sur présentation et remise d'icclles, avec tous les coupons d'intérêt attachés, au bureau de la Banque Provinciale du Canada à Montréal, à Québec ou à Drummondville, au choix du détenteur.Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er août 1950.Donné à Drummondville, comté de Pum-mond, ce 1er juin 1950.Le Secrétaire-trésorier, 42581-o MARCEL MARIER.(P.G.2313-47) D'Orsay Jewellery Limited Règlement N° III \u2014 Article 3 concernant la réduction du nombre des directeurs de cinq à trois: \"Les affaires de la compagnie seront administrées par un conseil d'administration composé de trois membres.\" Montréal, le 1er mai 1950.Vraie copie.(Sceau) La Sécrétaire-trésorière, 42583-0 ANNE G.-.TOURNAULT.(P.G.11737-50) Elecant Knitweau Limited Règlement N\" 2Jt Attendu qu'il a été reconnu du meilleur intérêt de la compagnie que le nombre des directeurs soit diminué de quatre à trois, que le nombre des directeurs soit et il est diminué de quatre à trois.Montréal, 10 avril 1956.Le Président de l'assemblé*; des directeurs, 42584 (Signé) JOSEF IIONIGWACHS.(P.G.12398-54) McCuaig Bros.& Co.Ltd.Un règlement augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de cinq à six.Que le premier paragraphe du règlement N° 2 des règlements de la compagnie soit amendé pour se lire comme suit : Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de six directeurs, trois desquels formeront quorum.Je, M.(i.Ibbotson, secrétaire-trésorier de McCuaig Bros.& Co.Ltd., certifie, par les présentes, que le précédent est une copie véritable et conforme du règlement décrété par le bureau de direction à son assemblée tenue le 9e jour de August 1st, 1909 (loan resolutions dated Decembers, 1953 and February 23, 1954).Public notice is hereby given that the School Commissioners for the municipality of the city of Drummondville.county of Drummond, shall redeem in advance, at par, on August 1st, 1956, by virtue of a redemption clause inserted in the said loan resolutions and reproduced on the bonds, the following bonds: 8 x 81,000 Nos M-328, 329, 330.331.332, 333, 334 and 335 of August 1st.1909; and 1 x 8500 No.D-3 of August 1st, 1900.The said bonds shall become due and payable and shall be paid and redeemed, both principal and interest, on the date mentioned hereinabove, in legal currency of Canada, with accrued interest up August 1st, 1951), upon presentation and surrender of same, together with all interest coupons attached thereto, at the office of the Provincal Bank of Canada, at Montreal.Quebec or at Drummondville, at the option of the holder.The said bonds shall cease to bear interest as from August 1st, 1956.Given at Drummondville, county of Drummond, this first dav of June, 1956.MARCEL MARIER.\u2022 42581 Seerctary-Treasurerr' (A.G.2313-47) D'Orsay Jewellery Limited By-law No.Ill \u2014 Article S concerning the decrease in the number of directors from five to three: \"The affairs of the Company shall be managed by a Board of Directors composed of three members.\" Montreal.May 1st.1956.True copy.(Seal) ANNE G.-JOURNAULT, 42583 Sec rotary-Treasu rer.(A.G.11737-50) Eleoant Knitwear Limited By-law No.>./t Whereas it is in the best interests of the company that the number of directors be decreased from four to three, that the number of directors be ami is decreased from four to three.Montreal, April 10, 1950.(Signed) JOSEF IIONIGWACHS, (President) Chairman of 42584-») Directors' Meeting.(A.G.12398-54) McCuaig Bros.& Co.Ltd.A by-law to increase the number of directors of the company from five to six.That the first paragraph of by-law number 2 of the company's by-laws be amended to read as follows: The affairs of the company shall be managed by a board of six directors, three of whom shall form a quorum.I, M.G.Ibbotson, secretary-treasurer of McCuaig Bros.& Co.Ltd., hereby certify the foregoing to be a true ami exact copy of the by-law enacted by the board of directors at its meeting held on the 9th day of January, 1950, 1990 GAZETTE OFF ICI ELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956.Tome 88, N° 2S janvier 1950 en la cité de Montréal, province «le Québec, et ratifié et confirmé à une assemblée «les actionnaires (le la compagnie tenue le 18e jour de janvier 1956, à laquelle les détenteurs de toutes les actions émises de la compagnie présents en personne ou représentés par procuration votèrent à l'unanimité en faveur de In sanction dudit règlement.Montréal.28 mai 1950.(Sceau) l.e Secrétaire-trésorier.425S6 M.(J.IBBOTSON.(P.G.12223-55) Lux Kmttin increase the number of directors of the company from three to four.Now therefore Ik- it enacted as a by-law of this company: That the number of directors «>f the company be varied by increasing the number of such directors from three to four, of whom three shall constitute a quorum.Fmactc«l this 0th tbinière, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th.19.50.Vol.88.No.83 1991 Donné au bureau du Secrétaire «le la province le 16 mai 1956.I.e Sous-secrétaire «!f May 1950.the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of June 1950.P.FRENETTE, 42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10663-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Sam Julius Inc.\", incorporated by letters patent «lated August 19th.1954.Notice is also given that from ami after the thirty-first day of May 1950, the said company has been dissolved.Dated at the offu-c of the Attorney General, this first dav of June 1950.P.FRENETTE.42540 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12049-54) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 2(5, chapter 270.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the sur-render of the charter of the company \"Allard Inc.\", inoorp«>ratcd bv letters patent i lui 1er juillet\t1957.\t.S 5.500.00 1er juillet\t\t 1er juillet\t\t 1er juillet\t19(50.\t0,000.00 1er juillet\t19(51.\t(5.500.00 1er juillet\t1902.\t7.000.00 1er juillet\t\t 1er juillet\t1964.\t7.500.00 1er juillet.\t1965.\t.7.500.00 1er juillet.\t19(56.\t.8,000.00 1er juillet\t1967,.\t8,000.00 1er juillet\t1968.\t8,500.00 1er juillet\t19(59.\t.9,000.00 1er juillet\t1970.\t.9,000.00 1er juillet\t1971.\t.9,500.00 1er juillet\t1972.\t10,000.00 1er juillet\t1973.\t.10,500.00 1er juillet\t1974.\t.11,000.00 1er juillet\t1975.\t.11,500.00 1er juillet\t1976.\t.11,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Hippolyte, comté de Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec, à Saint-Jérmc ou à Saint-Hippolyte, comté de Terrebonne.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941.être rachetées par anticipation, en tout ou cn partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 26 juin 1956.à 7.30 heures p.m., au Garage Belletête, Saint-Hippolyte, comté de Terre-bonne.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Hippolyte (comté de Terrebonne), ce 5 juin 1950.Le Secrétaire-trésorier.GEORGES-E.DESAUTELS.Saint-Hippolyte, (Comté de Terrebonne), P.Q.42577-o $165,000.00 of bonds of the parish of Saint-Hippolyte, county of Terrebonne, «lated July 1st, 1956 and redeemable serially from July 1st, 1957 to July 1st, 1976 inclusively, with interest at a rate of not less than 3% for maturities from 1957 to 19(5(5, 4% for those maturity from 19(57 to 1976 inclusive, and not over 4}4% for the maturities from 1957 to 1976 inclusive, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.Loan by-law No.1 IS Road work.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from July 1st.1956.The table of redemption is as follows: Table of redemption - SI(15,000.00 - 20 years Year Capital July 1st, 1957.8 5.500.00 July 1st.195S.5.500.00 July 1st, 1959.(5.000.00 July 1st, 19(50.0,000.00 July 1st, 1901.0,500.00 July 1st, 1902.7,000.00 July 1st, 19(53.7,000.00 .Inly 1st, 1964.7,500.00 July 1st.1905.7,500.00 July* 1st.1906.8.000.00 July 1st.1967 .8,000.00 July 1st, 19(58.8,500.00 July 1st, 1969.9,000.00 July 1st, 1970.9,000.00 Jul v 1st, 1971 .9,500.00 Julv 1st, 1972.10,000.00 July 1st, 1973.10,500.00 July 1st, 1974.11,000.00 Julv 1st.1975.11,500.00 Julv 1st.1970.11,500.00 ' The successful ten«lcrer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Saint-Hippolyte, county of Terrobonne.Capital and interest are payable at the bank mentionol in the loan procedure at Montreal, Quebec, Saint-Jérôme or Saint-Hippolyte, county «)f Terrebonne.The said bonds are, under the authority of chapter 212.Revised Statutes of Quebec, 1941, subject t«) 1)c redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; howev«'r, in case of partial redemption, the bomls to be re«leemed will be called f«>r payment ip reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certi-fic«l cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the e held on Tuesday, June 26, 1956, at 7.30 o'clock p.m., at Belletête Garage.Saint-Hippolyte, county of Terrebonne.The council is not hound to accept the highest or any of the tenders.Saint-Hippolyte (county of Terrebonne), this June 5, 1950.GEORGES-E.DESAUTELS.Secretary-Treasu re r.Saint-Hippolyte, (County of Terrebonne), P.Q.42577 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88.No.S3 2007 Province de Québec Les commissaires d'écoles protestantes pour la municipalité DE St-HuBERT (Comté de Chambly) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Mme Nelson IIowc, secrétaire-trésorier jusqu'à 7.30 heures p.m.à 125 ave.Cur/on, lundi, le 25 juin 1956, St-Lambert, Co.Chambly ou à (S.00 heures p.m., à l'école Royal Charles, Croydon, pour l'achat d'une émission de SI 16,000.00 d'obligations des Commissaires d'écoles Protestantes pour la municipalité de St-Hubert, Co.Chambly datées du 1er juin 1956 et remboursables par séries du 1er juin 1957 au 1er juin 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4}/>% par année payable scmi-annuellemcnt les 1er juin et 1er déc.de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt datée du ô avril 1956 \u2014 Extension de huit classes à l'École Royal Charles.Aux fins «le l'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er juillet 195(5.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 9116,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1957.x$14,000.00 1er juin 1958.x 14.500.00 1er juin 1959.x 15.000.00 1er juin 1960.x 16,000.00 1er juin 1961.x 16,500.00 1er juin 1962.2.000.00 1er juin 1963.2.000.00 1er juin 1964.2,000.00 1er juin 1965.2.000.00 1er juin 1966.2,500.00 1er juin 1967.2.500.00 1er juin 1968 .2,500.00 1er juin 1969.2,500.00 1er juin 1970.2,500.00 1er juin 1971.3,000.00 1er juin 1972 .3,000.00 1er juin 1973 .3.000.00 1er juin 1974 .3,500.00 1er juin 1975.3.500.00 1er juin 1976 .3.500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi de $77,080.00 accordé par le Sécrétaire de la province et payable en cinq versements de $15,410.00 chacun, de 1957 à 19(51 inclusivement, seront reçus et appliqués au service «le cet emprunt.Le bureau central des Écoles Protestantes «lu comté «le Chambly a passé une résolution le 16 avril 1956, conformément à l'article 33 de la Loi 8, George VI, chapitre 15, afin de se porter garant de la présente émission d'obligations par séries au montant de 8116.000.00 des Commissaires d'Écoles Protestantes pour la Municipalité de St-Hul>ert.L'a«ljudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêt courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Lambert, Co.Chambly.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, Québec ou St-Lambert, Co.Chambly.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 «les Statuts refondus de Québec, Province of Quebec The Protestant School Commissioners fou the municipality of St.hubert (County of Chambly) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Mrs.Nelson Howe.Secretary-Treasurer, until 7.30 o'clock p.m., at 425 Cur/on Avenue.St.Lambert.Co.Chambly, or at X.00 o'clock p.m.at the Royal Charles School, Croydon, Monday.June 25th, 1956, for the purchase of an issue «>f 81 1(5.000.00 of bonds of the Protestant School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, Co.Chambly.dated June 1st.1956 and redeemalbe serially from June 1st.1957 to June 1st.1970 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4 !\u2022':>% PC annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution «lated April 5th.1956 \u2014 Extension of eight classrooms to the Royal Charles School.Only for the purposes «>f awarding the issue, computation of interest will he made as from July 1st, 1956.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 S11U.O0O.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st.1957.\t.xSl 1.000\t\t00 \t\t14,500\t00 June 1st, 1959.\t\t1 5 000\t00 June 1st.1960.\t.x\t1(5,000\t00 June 1st, 1961.\t.x\t1(5,500\t00 June 1st, 1962.\t\t2.000\t00 June 1st, 1963.\t\t2.000\t00 June 1st, 1964.\t\t2.000\t00 June 1st, 1965.\t\t2.000\t00 June 1st, 1966.\t\t2.500\t00 June 1st, 1967.\t\t2,500\t00 June 1st, 1968.\t\t2,500\t00 June 1st, 1969.\t\t2,500\t00 June 1st, 1970.\t\t2,500\t00 June 1st, 1971.\t\t3,000\t00 June 1st, 1972.\t\t3,000\t00 June 1st, 1973.\t\t3,000\t00 June 1st, 1974.\t\t3,500\t00 June 1st, 1975.\t\t3,500\t00 June 1st.1976.\t\t3,500\t00 The \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount «>f $77,()K0.00, granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of $15.410.00 each, from 1957 to 1901 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.The Chambly County Protestant Central School Roard has passed a resolution on April 16th, 1956, in accordance with Section 33 of Act 8, George VI, Chapter 15, to become security for this 8116,000.00 serial bond issue of the Protestant School Commissioners for the Municipality of St.Hubert.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St.Lambert, Co.Chambly.Capital ami interest-arc payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or St.Lambert, Co.Chambly.The said bonds arc.under the authority of chapter 212.Revised Statutes of Quebec.1941, 2008 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql rÊBE(\\ Québec O juin 19,50, Tome 88, N° 23 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «les Commissaires d'Écoles protestantes qui sera tenue le 25 juin 1956 à S.00 heures p.m., à l'École Royal Charles, Croydon.Les Commissaires d'Ecoles Protestantes se réservent le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune «les soumissions.St-IIuhert, (Comté té & La lieu r Enrg \u2014 Peinture Provinciale Enrg\", et \"J.E.C«A)té Lumber Reg'd\", 833 est, rue Ste-Margue-rite-Québec, débiteur.Sales \u2014 Bakrupcy Act Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of the bankruptcy of J.Epiphane CY»té, general contractor carrying on business under the names ami style f \"Côté & Lafleur Enrg \u2014 Peinture Provinciale Enrg\" and \"J.E.Côté Lumber Reg'«l\",833 St.Marguerite Street, East.Quebec, debtor. 2012 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1,966, Tome 88.S° 2S AVIS DE VENTE Avis est par les présentes donné que, LUNDI, le SEIZE JUILLET, 1900 à ONZE heures de l'avant-midi, seront vendus par encan publie, aux bureaux des syndics soussignés, 111 Côte de la Montagne, Québec, les immeubles ci-après décrits, savoir: Item A: 1° Les lots sept cent trente-neuf-un-vingt et un-un, sept cent trente-neuf-un-un-quarante-sept-un (739-1-21-1) (739-1-1-47-1) tin cadastre officiel pour la paroisse de Beauport: 2° Une partie du lot sept cent trente-neuf-un-vingt et un (739-1-21 ptie.) du même cadastre, mesurant quarante et un pieds de largeur sur cent un pieds de profondeur, bornée au nord-est par la rue d'Est iniauvillc.au sud-est par le lot 739-1-21-5, au sud-ouest par une partie du lot 739-1-1-47 et au nord-ouest par le lot 739-1-21-1 ; 3° Une partie du lot sept cent trente-neuf-un-vingt et un (739-1-21 ptie.) du même cadastre, mesurant cent onze pieds de largeur, et cent un pieds de profondeur, bornée au nord-est par la rue d'Est iniauvillc au sud-est par le lot 739-1-21 -1.au sud-ouest par une partie du lot 739-1-1-47 et au nord-ouest par le lot 739-1-21-2 et par une autre partie du lot 739-1-21 ; 4° Une partie du lot sept cent trente-neuf-un-un-quarante-sept (739-1-1-47 ptie.) du même cadastre mesurant quarante et un pieds de largeur et soixante-douze pieds de profondeur, bornée au nord-est par la partie du lot 739-1-21 ci-dessus décrite en deuxième lieu, au sud-est par le lot 739-1-1-47-2, au sud-ouest par une autre partie du lot 739-1-1-47 destinée à servir de rue et au nord-ouest par le lot 739-1-1-47-1; 5° Une autre partie du lot sept cent trente-neuf-un-un-quarante-sept (739-1-l-47ptie.)mesu-rant cent un pieds de largeur et soixante-sept pieds de profondeur, bornée au nord-est par la partie du lot 739-1-21 ci-dessus décrite en troisième lieu, au sud-est par le lot 739-1-1-47-1, au sud-ouest par une autre partie du lot 739-1-1-47 destinée à servir de rue et au nord-ouest par une autre partie du lot 739-1-1-47; avec maisons dessus construites circonstances et dépendances; Sauf à distraire une partie des lots numéros 739-1-1-47 et 739-1-1-21, partie de terrain à céder à la Cité de (iiffard pour le prolongement de l'Avenue Assomption, jusqu'à la rue Alexandra.(Propriété sur ces terrains de cinq (5) logements, située sur la rue d'Estimauville).Item B: Un terrain ou emplacement situé sur le côté sud de la rue Ste-Marguerite, en la Cité de Québec, mesurant vingt-huit pieds et neuf pouces (28'9\") de front, sur cent, onze pieds (111') de profondeur, connu et désigné ledit emplacement comme étant le lot numéro mille sept cent onze (1711) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le quartier Jacques-Cartier, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.(Propriété de deux logements, avec bureaux et boutique à bois.).Les immeubles ci-haut décrits seront offerts en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et répartitions d'église qui peuvent exister.Les Titres et Certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressaut aux syndics soussi-gné*s, Lefaivre Marmette & Lefaivre, 111 Côte de la Montagne, Québec.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code de Procédure Civil et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949.NOTICE OF SALE Notice is hereby given that.MONDAY, the SIXTEENTH day of JULY 1956 at ELEVF2N o'clock in the forenoon, there shall be sold by public auction, at the offices of the undersigned trustees, 111 Mountain Hill, Quebec, the immoveables hereinafter described, to wit: Item A: 1.Lots seven hundred and thirty-nine-one, twenty-one-one.seven hundred and thirty-nine-one-one, forty-seven-one (739-1-21-1) (739-1-1-47-1) of the official cadastre for the parish of Beauport: 2.Part of lot seven hundred and thirty-nine-one-twenty-one (P.739-1-21) of same cadastre, measuring forty-one feet in width by one hundred and one feet in depth, bounded northeasterly by d'Est imauvillc Street, southeasterly by lot 739-1-21-5, southwesterly by part of lot 739-1-1-47 and northwesterly by lot 739-1-21-1 ; 3° Part of lot seven hundred and thirty-nine-one-twenty-one (739-1-21) of same cadastre, measuring one hundred ami eleven feet in width, and one hundred ami one feet in depth, bounded northeasterly by d'Estimauville Street, southeasterly by lot 739-1-21-1, southwesterly by a part of lot 739-1-1-47 and northwesterly bv lot 739-1-21-2 and by another part of lot 739-1-21; 4° Part of lot seven hundred and thirty-nine-one-one-forty-seven (P.739-1-1-47) of same cadastre measuring forty-one feet in width and seventy-two feet in depth, bounded northeasterly by that part of lot 739-1-21 hereinabove described in paragraph two, southeasterly by lot 739-1-1-47-2, southwesterly by another part of lot 739-1-1-47 intended for a street and northwesterly by lot 739-1-1-47-1; 5.Another part of lot seven hundred and thirty-nine-one-onc-forty-seven (P.739-1 -1-47) measuring one hundred and one feet in width and sixty-seven feet in depth, bounded northeasterly by that part of lot 739-1-21 hereinabove described in paragraph three, southeasterly by lot 739-1-1-47-1, southwesterly by another part of lot 739-1-1-47 intended for a street and northwesterly by another part of lot 739-1-1-47; with houses erected thereon, circumstances ami dependencies; Save and except part of lots 739-1-1-47 and 739-1-1-21, a part of the land granted to the City of Giffard in order to extend Assomption Avenue as far as Alexandre Street.(Property on said land of five (5) tenements, situated on d'Estimauville Street).Item B: A piece of land or emplacement situated on the south side of St.Marguerite Street, in the City of Quebec, measuring twenty-eight feet and nine inches (28'9\") in front, by one hundred and eleven feet (111') in depth, known and designated the said emplacement as being lot number one thousand seven hundred and eleven (1711) on the plan and book of reference of the official cadastre for Jacques Cartier Ward, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.(Property of two tenements, with offices and wood-shop).The immoveables hereinabove described shall be sold to the last ami highest bidder subject to rents and Church apportionments which may be existing.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the undersigned trustees, lefaivre Marmettc & Lefaivre.Ill Mountain Hill, Quebec.This sale is made in accordance with articles 716, 717 and 719A of the Code of Civil Procedure and also article 55 of the Bankruptcy Act 1949, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th.1966, Vol.88, No.23 2013 Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif et conformément à un jugement rendu par Mtre Robert Côté, régislraire des Faillites.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, ce 4 juin, 1950.Les Syndics, LEFAIVRE MARMETTE & LEFAIVRE.111 Côte de la Montagne, Québec.42507-23-2-o Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure N° 2208 (1955), \"En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Rémi Jolicoeur, 2463, Chemin Chambly Longueuil, Que.débiteur et J.Alexandre Dansereau.syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Désignation: Les lots numéros|sixcentsoixante-et-un et six cent soixante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre-vingt-quatorze (94-661-662) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Longueuil.dans le comté de Chambly.Avec toutes les bâtisses dessus érigées et non consumées, et portant les nos civiques 2441 nie Gamache.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, appa-tentes ou occultes.Sera vendu, cn vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, pour le district de Montréal (en faillite) rendu le 28 mai 1956, à l'enchère publique suivant la Loi pour ladite vente avoir l'effet du décret forcé au terme du Code de procédures civiles, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Antoine de Longueuil, LUNDI, le SEIZE JUILLET 1956 à ONZE heures de l'avant-midi.Conditions: Comptant.En plus, du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 2%% conformément à la Loi.Pour autres renseignements, et cahier des charges s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 4ème jour de juin 1956.Le Syndic, J.ALEXANDRE DANSEREAU.Bureau à 31.rue St-Jacques, ouest, Montréal, BE 3324.42568-23-2-0 This sale is equivalent to a sale by Sheriff and pursuant to a Judgment rendered by Me Robert Côté, Bankruptcy Registrar.Conditions of payment: Cash.Quebec, June 4, 1956.LEFAIVRE MARMETTE & LEFAIVRE, Trustees.Ill Mountain Hill, Quebec.42567-23-2 Province of Quebec, district of Montreal.Superior Court, No.2208 (1955) \"Sitting in Bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of: Rémi Jolicoeur, 2463 Chambly Road, Longueuil, Que., debtor ami J.Alexandre Dansereau, trustee.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit : Designation: Lots numbers six hundred and sixty-one and six hundred and sixty-two of the official subdivision of original lot number ninety-four (94-661-662) on the official plan and in the book of reference of the parish of St.Antoine de Longueuil.in the county of Chambly.With all the buildings thereon erected and not consumed, and bearing civic numbers 2441 Ga-mache street.As the whole presently stands with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes.Shall be sold, under judgment of the Superior Court, for the district of Montreal, (Sitting in Bankruptcy) rendered on May 28, 1956, at Public Auction according to Law so that the said sale will have the effect of a forced Sheriff's sale according to the terms of the ('ode of Civil Procedure, at the parochial church door of the parish of St-Antoine de Longueuil, MONDAY, JULY SIXTEENTH, 1956 at ELEVEN o'clock in the forenoon.Conditions: Cash.Moreover, over and above the purchase price, the purchaser shall pay Government Rights of 2l/2vo m conformity with the Law.For other information and list of charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this 4th dav of June, 1956.J.ALEXANDRE DANSEREAU, Trustee.Office at: 31, St.James Street West, Montreal, BE 3324.42568-23-2 Ventes par licitation Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 367352, Dame Rosalie Jarry et al, demandeurs, vs Arthur Cadieux, dit de Courville, et al, défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est par les présentes donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour supérieure siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, et rendu par l'honorable juge Georges F.Reid, le 4 mai 1956, dans une cause dans laquelle Dame Rosalie Jarry, veuve non remariée d'Armand Cadieux, de son vivant pressier de Montréal, domiciliée et résidant en les cité et district de Montréal; Georges Cadieux, journalier, Jean Claude Cadieux, journalier, tous deux des cité et district de Montréal; Dame Juliette Cadieux, épouse Sales by Licitation Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.367352, Dame Rosalie Jarry et al, plaintiffs, vs Arthur Cadieux.said of Courville.et al, defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Montreal, in the district of Montreal, and rendered by the Honourable Justice Georges F.Reid, on the 4th day of May 1956, in a case in which Dame Rosalie Jarry, unmarried widow of Armand Cadieux, in his lifetime Pressman of Montreal, domiciled and residing in the city and district of Montreal; Georges Cadieux, labourer, Jean Claude Cadieux, labourer, both of the city and district of Montreal; Dame Juliette Cadieux.wife 201 I GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec 0 juin 1056, Tome 88, N° 28 contractuellement séparée de biens d'Henri Audet, bourgeois de Montréal, des cité et district de Montréal, el son époux pour autoriser celle-ci si besoin est; Dame Thérèse Constantineuu, veuve non remariée d'Antonio Cadieux, de son vivant peintre de Montréal, domicilié et résidant en les cité et district de Montréal; Dame Françoise ('adieux, épouse commune en biens d'Albert Patry, journalier et ledit Albert Patry personnellement comme chef de la communauté et pour autoriser son épouse, tous deux «les cité et district de Montréal; Paul André Cadieux, chauffeur, domicilié et résidant en les cité et district de Montréal, sont demandeurs, et Arthur (\"adieux, «lit property of Henri Audet, gentleman of Montreal, of the city and district of Montreal, and her husband to authorize her if need be; Dame Thérèse ( 'onstantineau.unmarried widow of Antonio Cadieux, in his lifetime painter «)f Montreal, domiciled and residing in the city and district of Montreal; Dame Françoise Cadieux, wife common as to properly of Albert Patry.labourer, and the said Albert Patry pcrsonnaly as head of the community and to authorize his wife, both of the city and district of Montreal; Paul André Cadieux, chauffeur, domiciled and residing in the city and district of Montreal, are plaintiffs, and Arthur Cadieux, said «le Courville, domiciled and residing in the city and district of Montreal; Jeanne Cadieux said de Courville, wife of Auguste Briscbois, and the said Auguste Brisebois to authorize his wife for the purposes of these presents if need be, both of the city and district of Montreal, are defendants, ordering the licitation «>f the immoveables described as follows: \"A lot of land known and designated under number forty-seven of the official subdivision of lot number two hundred and ninety-nine (299-47) on the official plan and book of reference of the parish of Sault au Récollet, containing 50 feet in width by 75 feet in depth, English measure and more or less, with buildings thereon erected bearing civic numbers 11912 and 11914 of St.Real street of Montreal; \"A lot of land bounded in front by Laeordaire street, known and designated under number six hundred and sixty-three of the official subdivision of the original lot number twenty-one (21-663) on the official plan and book of reference of the parish of Longue-Pointe, city of Montreal, with buildings thereon erected bearing civic numbers 2887 and 2SS9 of the said Laeordaire street ;\" The above described immoveables will be sold by auction and ndjwlged to the highest ami last bidder, on the FOURTH day of JULY 1956.at HALF past TEN o'clock in the forenoon, in Court Room No.31, in the Court House of Montcal, or in any other room as circumstances may require, the said sale to be made subject to the charges, clauses and conditions mentioned in the List of {Charges filed in the Office of the Protbonotary of the Superior Court.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the Office of the Protbonotary of the said Court at least 12 days before the day fixed as aforesaid for the sale and ailjucidation and any opposition for payment must be file*! within 6 days following the adjudication; and failing the interested parties to file the said opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclose*! from so doing.A deposit of five hundred dollars (8500.00) shall be exacted before the sale from each and every bidder, f«>r the properly on St.Real Street, and of one thousand dollars (81,000.00) for the property on Laeordaire Street, by certified cheques to the order of the Protbonotary of the Superior Court.Montreal, Mav 29th.1956.PRÉVOST et GODIN, 42516-22-2-0 Attorneys for the plaintiffs.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.391643.Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at Montreal, on the 8th day of May, 1956, in a case wherein Leonard Rosenberg, accountant, of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.S3 2015 comptable, des cité et district de Montréal, est demandeur, et Dave (David) Marcus de la cité de Los Angeles, état de la Californie, Dame Isabel Marcus, épouse séparée de biens de Arthur Uslan et ce dernier une partie aux présentes pour autoriser sadite épouse à ces fins en autant qu'il peut être nécessaire suivant la Loi, tous deux du canton Greenbr' k, Dunellen, état de New Jersey et Darr.Ruth Marcus, divorcée non-remariée, majeure et usant de ses droits de la cité de Culver, état de la Californie, toutes lesdites parties des états unis d'Amérique; Dame Ethel Rosenberg, épouse séparée de biens de Joseph Cross et ce dernier une partie à ces présentes pour autoriser son épouse à ces fins en autant qu'il peut être nécessaire suivant la Loi, tous deux de la cité d'Outremont, district de Montréal; Dame Sadie Rosenberg, épouse séparée de biens de Abram (Abraham) Abramson et ce dernier une partie aux présentes pour autoriser sadite épouse à ces fins cn autant qu'il peut être nécessaire suivant la Loi, tous deux des cité et district de Montréal; Dame Pearl Cohen de la cité de Montréal, veuve de feu Morris Rosenberg, en son vivant du même lieu; Dame Annie Rosa Reichen-baum (quelquefois appelée Richenberg) des cité et district de Montréal, veuve de feu Joseph Rosenberg, en son vivant du même lieu et Dame Hariet Rosenberg, fille majeure et usant de ses droits des cité et district de Montréal, sont défendeurs, ordonnant la licitation de la propriété immobilière décrite comme suit: Ce certain emplacement situé cn la cité de Montréal et faisant partie du lot numéro deux cent soixante-dix-sept, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sault au Récollet et connu comme étant les subdivisions numéros trois cent vingt-deux, trois cent vingt-trois et trois cent vingt-quatre (277-322, 277-323 et 277-324).Ladite propriété immobilière décrite sera vendue à l'enchère publique et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur le HUITIEME jour d'AOÛT 1950 par ladite Cour, au Palais de Justice, à Montréal, district de Montréal, à DIX heures et TRENTE (10.30 a.m.) du matin, chambre 31 de la Cour supérieure de Montréal, sujette ai x clauses, charges et conditions stipulées au culiier des charges déposées au bureau du protonotaire de ladite Cour.Toutes oppositions à la présente vente, s'il y en a, doivent être déposées au moins douze jours (12) avant la date fixée, telle que susdite, pour ladite vente et toutes oppositions au paiement doivent être déposées dans les six (G) jours suivant l'adjudication sous peine de forfaiture.Un dépôt de S350.00 sera exigé de tout offrant et enchérisseur avec son offre.Montréal, 1er juin 1950.Le Procureur du demandeur, J.R.BOGANTE.J.R.Bogante, C.R., 10 est, rue St-Jacques, Montréal.42557-23-2 Ventes pour taxes Province de Québec Cité de Sherbrooke VENTE DE PROPRIÉTÉS POUR TAXES Avis public est par les présentes donné par le city and district of Montreal, is plaintiff, and Dave (David) Marcus of the city of Los Angeles in the State of California, Dame Isabel Marcus, wife separate as to property of Arthur Uslan and the latter a parly to these presents to authorize his said wife for these purposes in so far as may be necessary according to law, both of Greenbrook township, Dunellen, in the State of New Jersey and Dame Ruth Marcus, unremarried divorcee of the full age of majority et usant de ses droits of the city of Culver of the State of California, all of the said parties of the United States of America; Dame Ethel Rosenberg, wife separate as to property of Joseph Gross and the latter a party to these presents to authorize his wife for these purposes in so far as may be necessary according to law, both of the city of Outremont, district of Montreal; Dame Sadie Rosenberg, wife separate as to property of Abram (Abraham) Abramson, and the latter a party to these presents to authorize his said wife for these purposes in so far as may be necessary according to law, both of the city and district of Montreal; Dame Pearl Cohen of the city of Montreal, widow of the late Morris Rosenberg, during bis lifetime of the same place; Dame Annie Rosa Reichenbaum (sometimes referred to as Richenberg) of the city and district of Montreal, widow of the late Joseph Rosenberg, during his lifetime of the same place and Dame Hariet Rosenberg, fille majeure et usant de ses droits of the city and district of Montreal, arc defendants, ordering the licitation of the immoveable described as follows; That certain emplacement situated in the city of Montreal and forming part of lot number two hundred and seventy-seven, on the official plan and book of reference of the parish of Sault au Récollet and known as subdivisions numbers three hundred and twenty-two, three hundred and twenty-three and three hundred and twenty-four (277-322, 277-323 and 277-324).The said described immoveable property will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the EIGHTH day of AUGUST 1956 by the said Court, in the Court House at Montreal, district of Montreal, at HALF past TEN of the clock (10.30 a.m.) in the forenoon in Room 31 of the Superior Court of Montreal, subject to the clauses, charges and conditions stipulated in the list of charges filed in the office of the Protbonotary of the said Court.Oppositions to sale, of any, must be fyled at least twelve (12) days before the day fixed, as aforesaid, for the said sale and oppositions for payment must be fyled within six (0) days after the adjudication, under pain of forfeiture.A deposit of $350.00 will be exacted from each and every bidder with his bid.Montreal, June 1st., 1956.J.R.BOGANTE, Attorney for the plaintiff.J.R.Bogante, Q.C., 10 St.James East, Montreal.42557-23-2-o Sales for Taxes Province of Quebec City of Sherbrooke SALE OF PROPERTIES FOR TAXES Public notice is hereby given by the undersign- GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome 88, N° S3 soussigné, Greffier de la cité de Sherbrooke, que les immeubles ei-dessous désignés seront vendus à l'enchère publique, à l'hotel-dc-ville, 145 nord, rue Wellington, dans ladite cité, MARDI, le VINT-SIXIÈME jour de JUIN 1956, à DIX heures de Pavant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires ainsi que des intérêts courus et des frais, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soint payés avant la vente : cd, city clerk of Sherbrooke, that the hereinafter described immoveables will be sold by public auction, at the city hall, 145 Wellington St.North, in the said city, on TUESDAY the TWENTY-SIXTH of JUNE, 1956, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of municipal and school taxes with accrued interest and costs incurred thereon, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale: Nom des propriétaires Name of property owners Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Phjlias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Dumas A.Philias.Wolfe Mme-Mrs Emmott J.27 Birch rue-St.Timmins, Ont.Midland, Cyrille.Michaud,-Cyrille.Dutil, Lionel.Mongeau, Amédée.Johnson, Mme-Mrs Frank North Hatley.Propriétaire inconnu-unknown.Rubins Ltd King Ouest-West.Localité Location De La Bruèro.Assomption.Assomption.King Est-East.Assomption.Assomption.Assomption.Assomption.Assomption.Assomption.St-Michel.Wellington Sud-South Olivier.Ruelle Auger.Dorval.McManamy.King O.Rioux .Roy.' Cadastre Cadastral number 899/157/14 Est-East.P.899, et 899-13 Est-East 899/2 P.899/1 Est-East.733/108 P.733/109 Est-East.P.22 B Rg.6 Abc Est-East P.22 B Rg.6 Asc.Est-East P.22 B Rg.6 Asc.Est-East.P.22 B Rg.6 Asc.Est-East.P.22 B Rg.6 Asc.Est-East.P.22 B Rg.6 Asc.Est-East.P.22 B Rg.6 Asc.Est-East.P.6 Sud-South.1444/34 Sud-South.P.1444/36 Sud-South.7/46 Sud-South.1537/21 1537 P.20 Sud-South.P.64 Orford.P.64 Orford.S-16 B Rg.10 Bâtisse seulement-building only Ascot.Les immeubles susdits sont tous décrits aux plan officiel et livre de renvoi de la cité de Sherbrooke.Donné en la cité de Sherbrooke, ce 29e jour «le mai 1956.Publié dans la Gazette officielle, La Tribune et le Sherbrooke Record, les 2 et 9 juin, 1956.42519-22-2-o Le Greffier, H.P.ÉMOND.The above immoveables are all described on the Official Plan and Book of References of the city of Sherbrooke.Given at Sherbrooke, this 29th day of May 1956.To be published in the Quebec Offiical Gazette La Tribune and the Sherbrooke Record on June 2nd and 9th 1956.H.P.ÉMOND, 42519-22-2-0 City Clerk.Province de Quebec Municipalité scolaire de la ville de mlstassini Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-après décrits seront vendus aux enchères à l'hôtel de ville de Mistassini, MARDI le VINGT-SIXIÈME jour de JUIN 1956, à DIX heures du matin pour les taxes scolaires et municipales, avec les intérêts et «lues tel que mentionnés ci-après, à moins que les taxes et cotisations «lues pour tels immeubles plus les taxes municipales, ainsi que les frais ne soient acquittés avant la date de la vente à l'enchère, à savoir: Province of Quebec School municipality of the town of Mistassini Notice is hereby given that the immoveables hereinafter described shall be sold by public auction at the city Hall of Mistassini, TUESDAY the TWENTY-SIXTH day of JUNE 1956, at TEN o'clock in the morning for municipal and school taxes together with interest due, as mentioned hereafter, unless the taxes and assessments owing on said immoveables plus the municipal taxes, as well as costs incurred shall have been paid prior to the date of the auction sale, to wit: \t\t\tTaxes\tTaxes\t Propriétaires\tRang\tN° de cadastre\tscol.\tmunie.\tTotal \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t Owners\tRange\tNo.of cadastre\tSchool\tMunie.\t \t\t\ttaxes\ttaxes\t Alfred Allard.\tX.\tP-6.\tS 48.89 74.40 12.87 129.27 19.27 741.36\t$ 111.36 122.08 75.87 143.99 81.36 1209.91\t$ 160.25 196.48 88.74 273.26 100.63 1951.27 \tX.\tP-6A-62.\t\t\t \tX.\tP-7.\t\t\t \tX.\tP-12-138.\t\t\t \tX.\tP-7.\t\t\t \tX.\tP-5A-1-2.\t\t\t \t\t\t\t\t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 9th, 1956, Vol.88, No.28 2017 Tous les immeubles ci-dessus sont sur le plan et livre de renvoi de la ville de Mistassini comté de Roberval.L'acheteur doit payer comptant ou par chèque certifié immédiatement après la vente.Donné en la ville de Mistassini ce 26ième jour de mai 1956.Le Secrétaire-trésorier, 42518-22-2-0 REAL LALANCEITE.Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité scolaire de StE-ThKRÉSE de l'Enfant-Jksus de Cowansville Avis public est par les présentes donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité scolaire de Ste-Thérèsc de l'Enfant-Jésus de Cowansville, que la propriété ci-dessous désignée, sera vendue à l'enchère, au bureau du soussigné à 112 rue John, Cowansville, le LUNDI le VINGT-CINQ JUIN 1956, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes scolaires et municipales pour un montant de soixante-dix dollars et quarante cinq sous ($70.45), avec intérêts, plus les frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, et dépenses ne soient payés avant la vente.Comme appartenant à M.Josaphat Sanscha-grin: o) La subdivision numéro vingt-huit (28) du lot numéro trois cent cinq (305) du plan et livre de renvoi officiel du Canton de Dunham.b) Toute cette partie du lot numéro trois cent cinq (305) du cadastre officiel du canton de Dunham, plus particulièrement décrite et bornée comme suit: bornée en front vers le nord-est rue Goyer, par le lot numéro trois cent cinq douze (305-12), vers le sud-ouest et est par des parties non subdivisées du lot numéro trois cent cinq (305), et vers le nord-ouest par le lot numéro trois cent cinq vingt-sept (305-27), mesurant cinquante (50) pieds de largeur par cent quarante-sept (147) pieds de profondeur formant une étendue de sept mille trois cent cinquante (7,350) pieds carrés en mesure anglaise, avec bâtisses dessus érigées.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles et sujettes au droit de retrait.Donné à Cowansville, P.Q.ce 24ième jour de mai 1956.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 42517-22-2-0 RENÉ MEUNIER.All the immoveables hereinabove are on the plan and book of reference of the town of Mistassini, county of Roberval.The purchaser shall pay in cash or by certified cheque immediately after the sale.Given in the town of Mistassini, this 26th day of May 1956.REAL LALANCETTE, 42518-22-2 Secretary-Treasurer.Province of Quebec The school commissioners for the municipality of StE-ThÉRÈSE de l'Enfant-Jésus of Cowansville Public notice is hereby given by the under signed, Secretary-Treasurer of the school commission of Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Cowansville, that the property hereinafter described will be sold by public auction, at the office of the undersigned at 112 John Street, Cowansville, MONDAY JUNE TWENTY-FIFTH, 1956 at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of School and municipal taxes for an amount of seventy dollars and forty-five cents (870.45), with interests, also incurred subsequently, unless these taxes, interests, and costs be paid before the sale.As belonging to Mr.Josaphat Sanschagrin : a) The subdivision number twenty-eight (28) of the lot number three hundred five (305) of the official plan and book of reference for the township of Dunham.b) All this part of lot number three hundred five (305) of the official plan for the township of Dunham, more particularly described and bounded as follows; bounded in front towards the north-east on Goyer street by lot number three hundred five twelve (305-12), towards the southwest and east by an unsubdivided part of lot number three hundred five (305), and towards the north-west by lot number three hundred five twenty-seven (305-27) measuring a width of fifty (50) feet on a depth of one hundred and forty seven (147) feet, containing in area seven thousand and three hundred and fifty (7,350) aquars feet in english measure, with houses and others buildings thereon erected.The said sale will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said property, and subject to the right of redemption.Given at Cowansville, P.Q.this 24th of May 1956.(Seal) RENÉ MEUNIER, 42517-22-2-0 Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Canada \u2014 Province de Québec District d'Abitibi Cour Supérieure, (\\7AL D'OR CONSTRUC-N° V2975.< V TION COMPANY LI-\\ MITED, corporation légalement constituée avec siège social à Val d'Or, SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Canada \u2014 Province of Quebec District of Abitibi Superior Court,/\\/AL D'OR CONSTRUC-No.V2975.< V TION COMPANY LI-\\ MITED, a corporation legally incorporated with head office at Val d'Or, dis- 2018 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 juin 1956, Tome SS, N° 23 district d'Abitibi, demandeur ys JOHN TOMA-ZIN, de Jacola, district d'Abitibi, défendeur.Un morceau de terre étant partie du lot numéro 09 rang 8 canton Dubuisson, mesurant 50 pieds de largeur par 100 de profondeur, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église Notre-Dame de Fatima de Val d'Or, le VENDREDI VINGT-DEUXIÈME jour de JUIN 1956 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, le 11 mai 1956.42412-20-2-o trict of Abitibi, plaintiff, vs JOHN TOMAZIN, of Jacola, district of Abitibi, defendant.A piece of land being part of lot number 69, range 8, township of Dubuisson measuring 50 feet in lenght by 100 in depth, with buildings thereon erected, circumstancics and dependencies.To be sold at the church door of Notre-Dame de Fatima of Val d'Or, FRIDAY, the TWENTY-SECOND day of JUNE 1956, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, May 11, 1956.42412-20-2 ARTHABASKA Canada \u2014 Province de Québec District d'Arthabaska Cour Supérieure, / TEAN MARC ROBERGE N° 11,122.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.