Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 juin 1956, samedi 30 (no 26)
[" Tome 88, NV26 2201 Vol.88, No.26 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Cn.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 30 juin 1956 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet-et août 1956.Québec, le 14 juin 1956.L'Imprimeur de la Reine, 42676-26-9-0 RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais- des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 30th, 1956 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1956.Quebec, June 14th, 1956.RÊDEMPTI PARADIS, 42676-26-9-0 Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2202 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 juin 1956, Tome 88, N° 26 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.'5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7> 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 centschacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502-1-52 Lettres patentes (P.G.11347-56) Alix Auto Limitée Alix Auto Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1956, constituant en corporation: Maurice Alix, Fernand Alix, garagistes, Marguerite Marcoux Alix, ménagère, épouse séparée de biens dudit Maurice Alix, et Blanche Gagnin Alix, ménagère, épouse séparée de biens dudit Fernand Alix, ces deux dernières dûment autorisées par the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: 4 The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502-1-52 Letters Patent (A.G.11347-56) Alix Auto Limitée Alix Auto Limited Notice is hereby given taht under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patenf have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1956, incorporating: Maurice Alix, Fernand Alix, garage-keepers.Marguerite Marcoux Alix, houserifc wife separate as to property, of the said Maurice Alix, and Blanche Gagnon Alix, house wife.wife separate as to property of the said Fernand Alix, the letter two duly authorized i QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 30th, 1956, Vol.88, No.26 2203 leurs maris, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de véhicules automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Alix Auto Limitée \u2014 Alix Auto Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1956.L*Assistant-procureur général suppléant, 42675-o P.FRENETTE.(P.O.11286-56) André Charest Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux mai 1956, constituant en corporation: André Charest, comptable, Camille Messara, avocat, et Gisèle Milette, secrétaire, fille majeure, tous de Sherbroke, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une comapgnie de placement, sous le nom de \"André Charest Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $40 chacune.Le siège de la compagnie sera 111, King, ouest, Sherbrooke, district judiciaire de Sain-François.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11259-56) A.Perrault Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six avril 1956, constituant en corporation: André Perrault, constructeur, Gérald Desparois et Robert Maillet, avocats, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"A.Perrault Construction Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège de la compagnie sera 1395, Scarboro, 'ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11279-56) Arkay Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq arvril 1956, constituant en corporation: Moses Samuel Yelin, avocat, Anna Mi-kula et Esther Monson, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de placements, sous le nom de \"Arkay Investment Corp.\", avec un by their husbands, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the industry and business of dealing in motor vehicles and to operate as garage-keepers, under the name of \"Alix Auto Limitée \u2014 Alix Auto Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11286-56) André Charest Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May, 1956, incorporating: André Charest, accountant, Camilli Messara, advocate, and Gisèle Milette, secretary, of full age, all of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on the operations of an investment company under the name of \"André Charest Inc.\" with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 shares of a par value of $40 each.The head office of the company will be at 111 King, West, Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11259-56) A.Perrault Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of April, 1956, incorporating: André Perrault, builder, Gérald Desparois and Robert Maillet, advocates, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of builders and general contractors, under the name of \"A.Perrault Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.\\ The head office of the company will be at 1395 Scarboro, town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11279-56) Arkay Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of April, 1956, incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Anna Mikula and Esther Monson, secretaries, filles majeurs, all of Montreal, for the following purposes: To act as an incestment company, under the name of \"Arkay Investment Corp.\", with a total 2204 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 juin 1956, Tome 88, N° 26 capital total de $40,000, divisé en 1.500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la coniapgnic sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11289-56) Asselin & Frères Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenatn-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq avril 1956, constituant en corporation: Germain Asselin, Jeannine Houle, épouse séparée de biens dudit Germain Asselin, tous deux de ville Saint-Michel, Fernand Asselin, plâtrier, et Rita Boissonneault, épouse séparée de biens dudit Fernand Asselin, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de plâtriers ou entrepreneurs-plâtriers, sous le nom de \"Asselin & Frères Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions communes de $50 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11475-56) Bachelor King Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1956, constituant en corporation: Mervin Aizer, John F.Barry, administrateurs, Mœ Silverstein, commis, Donald Kujan, avocat et Leona Green, teneur de livres, fille majuere, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Bachelor King Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de $4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11395-56) Baril Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1956, constituant en corpo- capital stock of 840,000, divided into 1,500 common shares of the par value of $10 each and into 2,500 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11289-56) Asselin & Frères Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Licutenat-Govcrnor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of April, 1956, incorporating: Germain Asselin, Jeannine Houle, wife separate as to property of the said Germain Asselin, both of ville Saint-Michel.Fernand Asselin, plasterer, and Rita Boissonneault, wife separate as to property of the said Fernand Asselin, the two latter of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of plasterers or plaster contractors, under the name of \"Asselin & Frères Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $50 each and 350 preferred shares of $100 each.\u2022 The head office of the comgay will be at ville Saint Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth dav of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11475-56) Bae'hclor King Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1956, incorporating: Mervin Aizer, John F.Barry, executives, M*oe Silverstein, clerk, Donald Kujan, advocate, and Leona Green, bookkeeper, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Bachelor King Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $4,000,000, divided into 4,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the comapny shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of May, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11395-56) Baril Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date tlie twenty-eighth day of April, 1956, incorporating: Philippe QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 80th, 1956, Vol.88, No.26 2205 ration: Philippe Lecompte, vendeur, Roger Al-lard, comptable, tous deux de Victoriavillc, et Jean-Paul Baril, industriel, de Warwick, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce des véhiculés automobiles, sous le nom de \"Baril Automobiles Inc.\", avec Un capital total de $100,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 400 actions privilégiées classe A de $100 chacune et en 400 actions privilégiées classe B de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoriavillc, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant.42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11560-56) Beaver Claims Service Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi'des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mai 1956, constituant en corporation: Charles A.Rainville, ajusteur d'assurances, Hélène Rainville, ménagère, mariée et séparée de biens dudit Charles A.Rainville et Jacques Marchessault, avicat, tous de Granby, pour les objets suivants: Faire des enquêtes ajuster ou déterminer toutes pertes ou réclavations, sous le nom de \"Beaver Clairns Service Company Limited\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune 250 actions privilégiées, actégoric A, de $100 chacune et 250 actions privilégiées, catégorie B, de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11325-56) Berthier Gas & Oil Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant.-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six avril 1956, constituant en corporation: Lewis Dillman, producteur d'huile, de Regina, province de Saskatchewan, Charles Edward Gibson, a-gent, et Jean Miquelon, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des reegerches pour découvrir des mines et minerais et les négocier sous le nom de \"Berthier Gas & Oil Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de 820,000, divisé en 20,000 actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.m Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.Lecompte, salesmen, Roger Allard, accountant, both of Victoriavillc, and Jean-Paul Baril, industrialist, of Warwick, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in motor vehicles, under the name of \"Baril Automobile Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 400 preferred class A shares of $100 each and into 400 class B preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Victoriavillc, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11560-65) Beaver Claims Service Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day May, 1956, incorporating:Charles A.Rainville, insurance adjuster, Hélène Rainville, housewife, married separate as to property from the said Charles A.Rainville, and Jacques Marchessault, attorney all of Granby, for the following purposes: To investigate, adjust or settle all losses or claims, under the name of \"Beaver Claims Service Company Limited\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of a par value of SI00 each, 250 preferred shares class A of $100 each, and into 250 preferred shares class B of $100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of Mav, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11325-56) Berthier Gas & Oil Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that wider the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of April, 1956, incorporating: Lewis Dillman, Oil producer, of Regina, in the province of Saskatchewan, Charles Edward Gibson, agent, and Jean Miquelon, advocate and Queen's Counsel, of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Berthier Gas & Oil Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 shares of SI each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, .42675-0 Acting Deputy Attorney General, 2206 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 juin 1956, Tome 88, N° 26 (P.G.11179-56) Brian Furs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1956, constituant en corporation: Louis Feigenbaum, avocat, Morris Shu-ter, comptable, tous deux de St-Laurent .et Hyman Solomon, avocat, de ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de fourrures, manteaux de fourrure et accessoires, sous le nom de \"Brian Furs Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actioms ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureaudu Procureur général, le vingt-trois avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(A.G.11179-56) Brian Furs Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of April, 1956, incorporating: Louis Feigenbaum, advocate, Morris Shuter, accountant, both of St.Laurent, and Hyman Solomon, advocate, of the town of Mount Royal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, furs coats and accessories, under the name of \"Brian Furs Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11548-56) C.A.Brossard Transport Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1956, constituant en corporation: Jean Brossard, notaire, Mariette Houle, secrétaire, fille majeure, tous deux de ville de Saint-Rémi, et Charles-Auguste Brossard, marchand, de ville de Laprairie, pour les objets suivants: Exercer les opérations dune compagnie de tranport, sous le nom de \"C.A.Brossard Transport Limitée\", avec un capital total de $90,000, divisé en 900 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laprairie, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11127-56) Canadian Mail Nor Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1956, constituant en corporation: Maurice Vincent, entrepreneur, Normand Vincent, comptable, et Jacques Vincent, industriel, tous de Drummondville, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneur en construction, sous le nom de \"Canadian Mau Nor Construction Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11526-56) Colonial Office and Store Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies *de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la (A.G.11548-56) C.A.Brossard Transport Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1956, incorporating: Jean Brossard, notary, Mariette Houle, secretary, spinster, both of the town of Saint-Rémi, Charles-Auguste Brossard, merchant, of the town of Laprairie, for the following purposes: To carry on the operations of a transportation company under the name of \"C.A.Brossard Transport Limitée\", with a total capital stock of $90,000, divided into 900 shares of $100 each.The head office of the company will be at Laprairie, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11127-56) Canadian Mau Nor Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1956, incorporating: Maurice Vincent, contractor, Normand Vincent, accounting, and Jacques Vincent, industrialist, all of Drum-monville, for the following purposes: To act as building contractor, under the name of \"Canadian Mau Nor Construction Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 feting Deputy Attorney General.(A.G.11526-56) Colonial Office and Store Equipment Ltd.' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 30th, 1956, Vol.88, No.26 2207 province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mai 1956, constituant en corporation: Maurice Tessier, Rosaire Bérubé, avocats, et Paula Marmcn, député protonotaire, fille majeure, tous de Rimouski, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'équipement de bureau, magasin, hôtel, restaurant, de môme que meubles et mobiliers de maison, sous le nom de \"Colonial Office and Store Equipment Ltd.\", avec un capu-tal total de 320,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-o P.FRENETTE.(P.G.11277-56) C.R.McLaughlin Furniture Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provinde de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq avril 1956, constituant en corporation: Clair Reginald McLaughlin, de Verdun, Hyman Steinberg, de Montréal et Simon Steinberg, de ville Mont-Royal, tous marchands, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de fournitures de ménage, articles et accessoires, meubles, ébénisterie, rembourrage, sous le nom de \"C.R.McLaughlin Furniture Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11473-56) Cubamina Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1956, constituant en corporation: Antoine Paré, avocat, de St-André Est, Arthur Henry Graham (îould, avocat de Westmount, Jean Thomas Vien, avocat de Préville, Hélène Verville, Suzanne Du-chesnay, Zoé Garon, Jacqueline Daoust, secrétaires filles majeures, et Évariste Lavoie, comptable, de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Cubamina Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de $3,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of May, 1956, incorporating: Maurice Tessier, Rosaire Bérubé, advocates, and Paula Marmen, deputy prothonolary, fille majeure, all of Rimouski, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To deal in office, store, hotel, and restaurant equipment, as well as furniture and suites thereof, under the name of \"Colonial Office and Store Equipment Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11277-56) C.R.McLaughlin Furniture Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of April, 1956, incorporating: Clair Reginald McLaughlin, of Verdun, Hyman Steinberg, of Montreal, and Simon Steinberg, of the town of Mount Royal, all merchants, for the following purposes: To manufacture and deal in household furnishings, articles and equipment, furniture, woodwork, upholstery, under the name of \"C.R.McLaughlin Furniture Inc.\", with -a total capital stock of $40.000, divided into 500 common shares of $10 each and into 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the comgany will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11473-56) Cubamina Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1956, incorporating: Antoine Paré, advocate, of St.Andrews East, Arthur Henry Graham Gould, advocate, of Westmount, Jean Thomas Vien, advocate, of Préville, Hélène Verville, Suzanne Duchesnay, Zoé Garon, Jacqueline Daoust, secretaries, spinsters, and Evariste Lavoie, accountant, of Montreal, forthe following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Cubamina Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $3,000,000, divided into 3,000,-000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of Mav, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General. 2208 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1956, Tome SS, N° 26 (P.G.11250-56) Desmarais & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de a première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1956, constituant en corporation: (iérard Beaupré, Marcel Trudeau, avocats, et Bernard Forest, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Desmarais & Fils Ltée\", avec un capital total de S40,000, divisé en 400 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville St-Picrre, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(A.G.11250-56) Desmarais & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1956, incorporating: Gérard Beaupré, Marcel Trudeau, advocates, anil Bernard Forest, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a building company under the name of \"\"\"Desmarais & Fils Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Ville St-Picrrc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11166-56) Derôme Real Estate Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six avril 1956, constituant en corporation: Maurice Riel, avocat, de Laprairie, Jean Gcoffrion, avocat, d'Outremont, et Lorraine Séguin, secrétaire, fille majeure, de Boucher-ville, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Derôme Real Estate Ltée\", avec un capital total de S5.000, divisé en 500 actions communes de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Mathieu, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11399-56) < D.Guidon Fourrures Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1956, constituant en corporation: Dolor Guindon, fourreur, Fabiola Tremblay, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Dolor Guindon, et Fernand Guindon, fourreur, tous de Montréal, pour les objets suivants : Manufacturer et exercer le commerce de fourres, sous le nom de \"D.Guindon Fourrures Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1956 L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-o P.FRENETTE.(P.G.11447-56) Dorrie Process of Canada Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenang-gouvcrneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1956, constituant en corporation: (A.G.11166-56) Derôme Real Estate Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of April, 1956, incorporating: Maurice Riel, advocate, of Laprairie, Jean Gcoffrion, advocate, of Outremont, and Lorraine Séguin, secretary, of full age, of Boucherville, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate, under the name of \"Derôme Real Estate Ltée\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Mathieu, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11399-56) D.Guidon Fourrures Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May 1956, incorporating: Dolor Guindon, furrier, Fabiola Tremblay, housewife, wife contractually separate as to property of the said Dolor Guindon, and Fernand Guindon, furrier, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, under the name of \"D.Guindon Fourrures Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11447-56) Dorrie Process of Canada Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1956, incorporating: Jack Rudner, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 80th, 195G, Vol.88, No.26 2209 Jack Riulner, Joseph Mcndclson, avocats, Celia Cohen ct Catherine Allin, secretaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et distribuer du \"mylar\" métallisé et produits d'iceux, sous le nom de \"Dorrie Process of Canada Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 20 actions ordinaires de 8100 chacune et 80 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1956.< L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11219-56) Dula Metals Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes,, en date du vingt-sept avril 1956, constituant en corporation: Frank Ladora, Pasquale Calderone, marchands, Georges Gervais, Michel Ladora, industriels et Orner Du-puis, chirurgien-dentiste, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais ct les négocier, sous le nom de \"Dula Metals Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de $4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.\u2022 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11599-56) Eklovc & Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1956, constituant en corporation: Cyril E.Schwisbcrg, avocat, Sonya Schneyer, et Anne Zifkin, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercre le commerce d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Eklove & Co.Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1010 ouest, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1965.Joseph Mcndclson, advocates, Celia Cohen and Catherine Allin, secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and distribute metallized mylar and products made thereof, under the name of \"Dorrie Process of Canada Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 20 common shares of SI00 each and into 80 preferred shares of SI00 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1950.P.FRENETTE, 42675-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11219-56) Dula Metals Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April, 1956, incorporating: Frank Ladora, Pasquale Calderone, merchants, Georges Gervais; Michel Ladora, industrialists, and Oiner Dupuis, surgeon-dentist, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Dula Metals Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 84,000,000, divided into 4,000,000 shares of SI each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11599-56) Eklovc & Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec; bearing date the twenty-third day of May, 1956, incorporating: Cyril E.Schwisbcrg, advocate, Sonya Schneyer and Anne Zifkin, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Eklove & Co.Limited\", with a total capital stock of $40, 000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at 1010 St.Catherine St.W., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 42675 P.FRENETTE.42675-o Acting Deputy Attorney General. 2210 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 juin 1956, Tome 88, N° 26 (P.G.11268-56) Garage Desjardins & Frères Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq avril 1956, constituant en corporation: Y von Jasmin, avocat, Estelle Théricn et Rita Dufresne, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme vendeurs de véhicules automobiles et comme garagistes, sous le nom de \"Garage Desjardins & Frères Inc.\", avec un un capital total de $30,000, divisé en 3,000 actions communes de $1 chacune et en 270 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville de L'Abord-à-PIouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11521-56) Gatineau Plumbing & Heating Ltd.Plomberie & Chauffage Gatineau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1956, constituant en corporation: Emile Hurtubise, plombier, Maurice Dostaler, avocat, et Roland Théorèt, notaire, tous de Gatineau, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur en plom-\\berie et en chauffage, sous le nom de \"Gatineau Plumbing & Heating Ltd.\u2014 Plomberie & Chauffage Gatineau Ltée\", avec un capital total de $80,000, divisé en 8,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 273, rue Notre-Dame, Gatineau, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-o P.FRENETTE.(P.G.11387-56) H.Nathanson Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six avril 1956, constituant en corporation: Henry Nathanson, entrepreneur en construction, de Westmount, Isidore Reuben Pro-zoff, avocat, et Sarah Peters, sténographe, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"H.Nathanson Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six avril 1956.(A.G.11268-56) Garage Desjardins & Frères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of April, 1956, incorporating: Yvon Jasmin, advocate, Estelle Thérien and Rita Dufresne, secretaries, filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the foolwing purposes: To carry on business as salesmen of motor vehicles and garage-keepers, under the name of \"Garage Desjardins & Frères Inc.\", with a total stock of $30,000, divided into 3,000 common shares of $1 each and 270 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at L'Abord-à-Plouffe, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11521-56) Gatineau Plumbing & Heating Ltd.Plomberie & Chauffage Gatineau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1956, incorporating: Emile Hurtubise, plumber, Maurice Dostaler, advocate, and Roland Théorèt, notary, all of Gatineau, for the following purposes:/ To carry on a business as plumbing and heating contractor under the name of \"Gatineau Plumbing & Heating Ltd.\u2014 Plomberie & Chauffage Gatineau Ltée\", with a total capital stock of $80,000, divided into 8,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 273 Notre-Dame St., Gatineau, judicial district of Hull._ Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11387-56) H.Nathanson Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of April, 1956, incorporating: Henry Nathanson, building contractor, of Westmount, Isidore Reuben Prozoff, advocate, and Sarah Peters, stenographer, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a construction company, under the name of \"H.Nathanson Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of April, 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 42675 P.FRENETTE.42675-0 Acting Deputy Attorney General, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 80th, 1966, Vol.88, No.26 2211 (P.G.11239-56) Hôtel Kennebec, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1956, constituant en corporation: Philias Goulet, hôtelier, Rosa-Anna Rancourt Goulet, ménagère, épouse judiciairement séparée de biens dudit Philias Goulet, tous deux de Levis, et Fernande Goulet Halle, ménagère, épouse séparée de biens de Denary Halle, de Lauzon, pour les objets suivante: Faire affaires comme hôteliers, sous le nom de \"Hôtel Kennebec, Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en $1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 115, rue Commerciale, Levis .district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-0 P.FRENETTE.(P.G.11468-56) Hôtel Le Chatelet Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1956, constituant en corporation: Roger Paquet, Jean-Charles Wirz, hôteliers, de Morin-Heights, et Robert Brullman, charcutier, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers, sous le nom de \"Hôtel Le Chatelet Limitée\", avec un capital total de $75,000, diivsé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Morin-Heights, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-Q P.FRENETTE.(P.G.11171-56) Imprimerie du Nord Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1956, constituant en corporation: Jean-Marie Duchaîne, bijoutier, Mme Carmen Tremblay Duchaîne, ménagère, épouse contrac-tuellement séparée de biens dudit Jean-Marie Duchaîne, et dûment autorisée par ce dernier, et Bertrand Gagnon, avocat, tous de Dolbeau, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'appareils de reproduction sonore et de communication, d'articles ou accessoires ou machines de bureau; faire affaires comme éditeur et imprimeur, sous le nom de \"Imprimerie du Nord Ltée'', avec un capital total de $30,000, divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la Compagnie sera 659, boulevard Walberg, Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675-o P.FRENETTE.(A.G.11239-56) Hôtel Kennebec, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1956, incorporating: Philias Goulet, hotel-keeper, Rose-Anna Rancourt Goulet, housewife, wife judicially separate as to property of the said Philias Goulet, both of Levis, and Fernande Goulet Halle, housewife, wile separate as to property of Denary Halle, of Lauzon, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers under the name of \"Hôtel Kennebec, Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at 115 Commercial St., Levis, judicial district of Québec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11468-56) Hôtel Le Chatelet Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, lettres patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1956, incorporating: Roger Paquet, Jean Charles Wirz, hotel-keepers, of Morin Heights, and Robert Brullman, pork-butcher, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers, under the name of \"Hôtel Le Chatelet Limitée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Morin Heights, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11171-56) Imprimerie du Nord Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April 1956, incorporating: Jean-Marie Duchaîne, jeweller, Mrs.Carmer Tremblay Duchaîne, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean-Marie Duchaîne, and duly authorized by the latter, and Bertrand Gagnon, advocate, all of Dolbeau, for the following purposes: To manufacture and carry on a business dealing in loud-speaking apparatus and communications, office articles, or accessories or machines; to carry on a business as editor and printer, under the name of \"Imprimerie du Nord Ltée\", with a total capital stock of $30,000, divided into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at 659 Walberg Boulevard, Dolbeau, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1956.P.FRENETTE, 42675 Acting Deputy Attorney General. 2212 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 juin 1956, Tome 88, N° 26 (P.G.L1402-56) Independent Poultry Farms Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six avril 1956, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Wcstmount, Murray Lapin, avocat, de Ilampstcad, Morris M.Weiner, Pearl Charnetsky, avocat, fille majeure, de Montréal, et Shirley Muggeridge, secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce de produits maraîchers, de volailles, oeufs et produits alimentaires, sous le nom de \"Independent Poidtry Farms Ltd.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 1.500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5447 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six avril 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 42675 P.FRENETTE.(P.G.11306-56) Jaco Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq avril 1956, constituant en corporation: Mclvin Rothman, avocat, de Westmount, Yvonne Bélanger et Sylvia Vineberg, toutes deux secrétaire, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Jaco Enterprises Limited\", avec un capital total oration of their religious congregation, under the Church Incorporation Act (R.S.1941, ch.311) of the Province of Quebec.Miss M.KENNEDY, 42556-23-5-0 Church Clerk.(A.G.10903-56) Claude Vermette et Associés Inc.Claude Vermette & Associates Inc.By-law concerning the increasing of the directors from three to seven.\"Directors: II.The affairs of the company shall be managed by a Board of Directors composed of seven directors, each of whom at the time of his election and during his term of office, shall be the holder of at least one of the Company's shares, and shall have paid any required payment thereon.\" True copy.MARIETTE VERMETTE, 42678 Secretary.Fairmount Realties ltd.By-laio No.ll Whereas the company has ceased to carry on business except for the purpose of winding-up its affairs and has no debts, liabilities, orobliga-tions that have not been paid of provided for: Be it resolved: That the assets of the company be distributed rateably among the shareholders.Montreal, June 15, 1956, Fairmount Realties Ltd, N.L.RAPPAPORT, 42680-o Per Attorney for the company.(A.G.11277-55) Quebec Smelting & Refining Limited (No Personal Liability) Byl-aw No.1,2 1.The number of Directors of this company is hereby increaed from five to seven and By-law No.12 as amended by By-laws No.39 and No.40, be and -it is hereby further amended by deleting therefrom the word \"five\" and substituting therefor the word \"seven\".2.By-law No.19 be and it is hereby amended by deleting thcreform the word \"two\" as it appears in the third line thereof and substituting therefor the wore \"three\", so that hereafter the quorum for meetings of Directors shall be fixed at three.Certified true copy: Montreal, P.Q., June 11th, 1956, J.O.SABOURIN, 42681-o Secretary.(A.G.16347-52) Boivin & Levasseur Inc.By-law No.4 respecting the number of directors of \"Boivin & Levasseur Inc.\" It is hereby resolved by by-law No.4, to increase from three to five the number of directors, of the company. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 30th, 1956, Vol 88, No.26 2229 Lu et adopté et signé, ce douzième jour de décembre 1955.Vraie copie.(Sceau) I^e Secrétaire, 42697-0 JACQUES LAPOINTE.(P.G.11099-55) Continental Iron & Titanium Mining Limited (No Personal Liability) Règlement N° 1, par.S-A concernant la modification au nombre des directeurs.\"Le nombre des directeurs de la compagnie \"Continental Iron & Titanium Mining Ltd.\" (N.P.L.) est changé de dix (10) qu'il était auparavant à celui de onze (11) et le règlement N° 1, par.3 de la compagnie est modifié en conséquence.\" Copie certifié.Le Secrétaire, 42098-o A.MARKIW.(P.G.10737-55) Avis esi donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le dix-huit juin 1956, les règlements nos 1, 2 et 3 de \"The Chapeau Community Hospital Incorporated\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix-neuf juin 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 42699-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.10778-56) The Gatineau Curling Club Extrait des règlements de la corporation nommée ci-dessus, tel qu'adopté par les membres le 18 mai 1956, concernant une augmentation du nombre des directeurs de trois à dix: \"Règlement quatre\u20141.Bureau de direction (a) Le bureau de direction sera composé de dix membres.\" Le Secrétaire-trésorier, 42700 L.H.DUNNING.(P.G.10784-50) Quebec Heart Foundation Inc.Extrait des règlements de la corporation nommée ci-dessus, tels qu'adoptés par les membres le 3 mai 1950, concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs de trois à dix-huit: \"Bureau de direction exécutif \u2014 Nombre de directeurs \u2014 8.Le commerce et les affaires de la compagnie de la fondation seront gérés et administrés par un bureau de direction exécutif composé de dix-huit membres.\" Certifié vraie copie.Le Secretaire 42703 Mme.ARLINE KOLOMEIR.(P.G.11604-50) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le vingt-trois juin 1956, les règlements I et II de la corporation.Read, adopted and signed, this twelfth day of December 1955.True copy.(Seal) JACQUES LAPOINTE, 42697 Secretary.(A.G.11099-55) Continental Iron & Titanium Mining Limited (No Personal Liability) By-law No.1, par.8-A varying the number of directors \"The number of directors of the company \"Continental Iron & Titanium Mining Ltd.\" (N.P.L.) is hereby changed from ten (10), as previously provided for, to eleven (11) and bylaw No.1, par.3 is hereby amended accordingly.\" Certified Copy.A.MARKIW, 42698-0 Secretary.(A.G.10737-55) Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary approved on the eighteenth clay of June 1956, by-laws Nos.1, 2, and 3 of \"The Chapeau Community Hospital Incorporated\", and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the nineteenth day of June 1956.JEAN BRUCHÉSI, 42699 Under Secretary of the Province.(A.G.10778-56) The Gatineau Curling Club Extract of the by-laws of the above named Corporation, as adopted by the members on May 18,1956, concerning an increase in the directorate there of from three to ten: \"By-law four \u2014 1.Board of Directors (a) The Board of Directors shall consist of ten members.\" L.H.DUNNING, 42700-o Secretary-Treasurer.(A.G.10784-56) Quebec Heart Foundation Inc.Extract of the By-Laws of the above named corporation, as adopted by the members on May 3rd, 1956, concerning the increase in the directorate thereof from three to eighteen: \"Governing Board \u2014 Number of Directors \u2014 8.The business and affairs of the Foundation shall be managed and administreed by a Governing Board consisting of eighteen members.\" Certified a true copy.Mrs.ARLINE KOLOMELR, 42703-o Secretary.(A.G.11604-56) Notice is given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on June twenty-third, 1956, by-laws I and II fo the cor- 2230 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 juin 1956, Tome 88, N° 26 \"Hôpital Richelieu Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-six juin 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 42705-o JEAN BRUCHÉSI.poration \"Hôpital Richelieu Inc.\", and such, in conformity with the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary and June twenty-sixth, 1956.JEAN BRUCHÉSI, 42705 Under Secretary of the Province.(P.G.13201-54) Laduboro Oil Ltd.(No Personal Liability) Règlement numéro sept concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à sept.\"Sur motion de M.Léo-T.Julien, secondée par M.J.-G.Delegrave et adoptée à l'unanimité que: 1.Le nombre des directeurs de Laduboro Oil Ltd.(N.P.L.) est changé de trois qu'il était à sept et le règlement numéro un, article III, section (6) de la compagnie est modifié en conséquence .\" Certifié vraie copie, ce lie jour de juin 1956.Le Secrétaire, 42706-o CLAUDE BOUTET, m.d.(A.G.13201-54) Laduboro Oil Ltd.(No Personal Liability) By-law number seven concerning the increase in the number of Directors from three to seven.\"Upon the motion of Mr.Léo-T.Julien, seconded by Mr.J.-G.Delagrave and unanimously adopted that: 1.The number of the Directors of Laduboro Oil Ltd.(N.P.L.) is changed from three that it was, to seven and by-law number one, article III, section (b) of the company is amended in consequence thereof.\" Certified true copy, this 11th day of June, 1950.CLAUDE BOUTET, m.d.42700 Secretary.(P.G.10307-56) Brome Lake Ducks Limited Règlement spécial \"C\" Un règlement pour diminuer le nombre des directeurs.Attendu qu'il est jugé opportun de diminuer le nombre des directeurs de la compangie de cinq à trois; En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie: Que le nombre des directeurs de la compagnie soit changé en diminuant le nombre de ces directeurs de cinq à trois; Et que le règlement N° II de la compagnie soit amendé en y rayant le mot \"cinq\" où il apparaît en le remplaçant par le mot \"trois\".Montréal, 18 juin 1956.Brome Lake Ducks Limited Le Secrétaire-trésorier, 42707 G.L.PRIME.(A.G.10307-56) Brome Lake Ducks Limited Special By-law \"C\" By-law decreasing number of Directors.Whereas it is expedient to decrease the number of directors of the Company from to five three; Now, therefore, be it enacted as axby-law of the company: \\ That the number of directors of the Company be varied by decreasing the number of such directors from five to three; And that By-law No.II of the Company be amended by deleting the word \"five\" appearing and replacing it with the word \"three\".Montreal, June 18, 1956.G.L.PRIME, Secretary-Treasurer.42707-o Brome Lake Ducks Limited AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association Patronale des Barbiers et Coiffeurs et Coiffeuses de La Tuque et District\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la province le vingt-six juin 1950.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à La Tuque, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, 42708-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association Patronale des Barbiers et Coiffeurs et Coiffeuses de La Tuque et District\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on June twenty-sixth, 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is at La Tuque, judicial district of Quebec.JEAN BRUCHÉSI, 42708 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 30th, 1956, Vol.88, No.26 2231 Chartes \u2014 Abandon de Walsh Adhesives Corp.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Walsh Adhesives Corp.\" s'adressera au Lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, en vertu des dispositions de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.Montréal, 21 juin 1956.Le Procureur de la compagnie, 42679 (Signé) S.GREENBLATT.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Fairmount Realties Ltd., constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, dagées du 3 septembre 1946, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 15 juin 1956.Le Procureur de Fairmount Realties Ltd., 42680 N.L.RAPPAPORT.Boston Metal Products Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Boston Metal Products Ltd., constitué en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 21e jour de juin 1956.Le Secrétaire, 42682 S.D.RUDENKO.Avis est par les présentes donné que M.E.Binz Silk Company of Danville Limited ayant son bureau-chef dans les cité et district de Montréal, s'adressera au Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner ses letters patentes, à partir de et après la date qu'il lui plaira de déterminer.Daté à Montréal, ce 27e jour de juin, 1956.Les Procureurs de la Requérante, STEIN & STEIN.Ch.1075-1435, St-Alexandre, Montréal, Que.42709-o Avis est donné que la compagnie Sprott Commercial College Inc.demandera au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, la compagnie n'ayant pas de dettes ou obligations.Montréal, 22 juin 1950.Les Procureurs de Sprott Commercial College Inc., 42710 CHAIT & ARONOVITH.Département des Affaires municipale Le soussigné donne avis que, tel que demandé par une résolution du 4 juin 1950, adoptée par le conseil municipal de Sainte-Marcelline de Kildare, dans le comté de Joliette, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a décrétée, en date du 26 juin 1956, que les publications de tous les avis publics, règlements, réso- Charters \u2014 Surrender of Walsh Adhesives Corp.Notice is hereby given that \"Walsh Adhesives Corp.\" will make application to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec, for leave to surrender its Charter, under the provisions of Section 26 of the Quebec Companies' Act.Montreal, June 21st, 1956.(Sgd) S.GREENBLATT, 42079-o Attorney for the Company.Notice is hereby given that Fairmount Realties Ltd., incorporated by letters patent, of the province of Quebec, dated September 3rd, 1946, will make application for leave to surrender its Charter.Montreal, June 15th, 1956.N.L.RAPPAPORT, 42680-o Attorney for Fairmount Realties Ltd.Boston Metal Products Ltd.Notice is hereby given that Boston Metal Products Ltd., incorporated under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its Charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 21st day of June, 1956.S.D.RUDENKO, 42682-0 Secretary.Notice is hereby given that M.E.Binz Silk Company of Danville Limited, having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Honourable Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, for leave to surrender its letters patent, from and after the date which he will be pleased to determine.Dated at Montreal, this 27th day of June, 1956.STEIN & STEIN, Attorneys for Petiotiner, Suite 1075-1435 St.Alexander St., Montreal, Que.42709-o Notice is hereby given that Sprott Commercial College Inc., will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec, for leave to surrender the charter of the Company, having no assets or liabilities.Montreal, June 22nd, 1956.CHAIT & ARONOVITH, Attorneys for Sprott 42710-o Commercial College Inc.Department of Municipal Affairs The undersigned gives notice that, as requested in resolution dated June 4, 1956, of the Municipal Council of Sainte-Marcelline de Kildare, county of Joliette, and pursant to the provisions of Article 130, of the Municipal Code, he has enacted, under date of June 26, 1956, that the publications of all public notices, by-laws, 2232 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SO juin 1956, Tome 88, N° 26 lut ions ou ordres de la dite corporation, sauf resolutions or orders of the said corporation, with celles requises dans la Gazette Officielle de Québec, the exception of those required in the Quebec se feront, à l'avenir, dans la langue française Officiai Gazette, be made, henceforth, in the French seulement.language only.Le présent avis est publié en vertu de l'article The present notice is published in conformity 131 du Code municipal (10 George VI, chapitre with Article 131, of the Municipal Code, (10 55, section 2).George VI, chapter 55, section 2).Québec, le 26 juin 1956.Quebec, June 26th, 1956.Le Ministre des Affaires municipales, YVES PRÉVOST, Q.C., 42696-Q YVES PRÉVOST, C.R.42696 Minister of Municipal Affairs.Département de l'Instruction Publique Department of Education N° 1218-53.Québec, le 15 juin 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Sacré-Cœur-de-Jésus paroisse, dans le comté de Beauce_le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de Sainte-Clotilde, même comté.Ce territoire est décrit comme suit, savoir: une partie du lot originaire n° 28 du rang VII du canton de Tring et mesurant environ 18 arpents de longueur par 5 arpents de largeur, bornée du côté nord-est par la ligne du rang VII du même canton et au nord-ouest par la vieille route du comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.42657-25-2-0 0.J.DÉSAULNIERS.No.1218-53 Quebec, June 15, 1956.Application is made to detach from the school municipality of Sacré-Cœur-de-Jésus parish, in the county of Beaucè, the territory herebelow described to annex it to the school municipality of Ste-Clotilde, same county.This territory is described as follows, to wit : A part of the original lot No.28 of range VII of the township of Tring and measuring about 18 arpents, in length by 5 arpents in width, bounded on the northeast by the line or range VII of the same township and on the northwest by the old road of the countv.O.J.DÊSAULNIERS, 42657-25-2 Superintendent of Education.N° 303-56.Québec, le 26 juin 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de Chicoutimi, dans le comté de Chicoutimi, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de la cité de Chicoutimi, même comté.Cedit territoire comprend une partie des lots originaires nos 67 et 68 et leurs subdivisions, du rang I sud-ouest du chemin Sydenham, des plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Chicoutimi, division d'enregistrement de Chicoutimi, et est borné comme suit: du côté nord-ouest par le lot 69 du rang I ou limite actuelle sud-est de la cité de Chicoutimi; du côté nord-est par la ligne de division entre les rangs I sud-ouest chemin Sydenham et I nord-est chemin Sydenham ou limite sud-ouest actuelle de la cité de Chicoutimi; du côté sud-est par le lot 66 dudit rang I sud-ouest chemin Sydenham et du côté sud-ouest par une partie desdits lots nos 67 et 68 suivant le prolongement en ligne droite vers le sud-est de la limite actuelle sud-ouest de la cité de Chicoutimi ou plus précisément suivant le prolongement du côté nord-est du chemin St-Thomas.Ce territoire ainsi décrit contient une superficie de 46.4 acres.Le Surintendant de l'Instruction publique, 42712-26-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.303-50.Quebec, June 26, 1956.Application is made to detach from the school municipality of the parish of Chicoutimi, in the county of Chicoutimi, the territory hereinafter described to annex it to the school municipality of the city of Chicoutimi, same county.This said territory is comprised of one part of the original lots Nos.67 and 68 and their subdivisions, of range I southwest of Sydenham road, on the official plan and in the book of reference of the parish of Chicoutimi, registration division of Chicoutimi and is bounded as follows: on the northwest side by lot 69 of range I or present limits southeast of the city of Chicoutimi; on the northeast side, by the dividing line between ranges I southwest of Sydenham road and I northeast Sydenham road or present southwest limit of the city of Chicoutimi; on the southeast side by lot 66 of the said range southwest Sydenham road and on the southwest side by a part of the said lots Nos.67 and 68 following the prolongation in a straight line towards the southeast of the present southwest limit of the city of Chicoutimi or more precisely, following the prolongation of the northeast side of St.Thomas road.This territory thus described contains a superficial area of 46.4 acres.O.J.DÊSAULNIERS, 42712-26-2 ' Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS NOTICE Cadastre officiel de la paroisse de St-Flavien \u2014 Officiai cadastre of the parish of St.Flavien \u2014 Division d'enregistrement de Lotbinière.Registration division of Lotbinière.Avis est par la présente donné que le lot 219-1 Notice is hereby given that lot 219-1 is can- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 80th, 1956, Vol.88, No.26 2233 est annulé en vertu de l'article 2174A du Cole celled in virtue of Article 2174A of the civil Code.civil.Quéhec.le S mai 1956.Le Département des Terres et Forets.Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 42677-0 AVI LA BÉDARD.Quebec.May the Sth, 1956.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVI LA BÉDARD, 42677-0 Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la fourrure, section du détail, région dé Montréal, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 643 du 20 mai 1953: La partie de première part sera remplacée par la suivante: \"Les Maîtres-Fourreurs Associés du Québec Inc.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 30 juin 1956.42695-o Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collectivelabour agreement reating to the fur industry, retail section, district of Montreal, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree number 043 of May 20th, 1953: The contracting party of the first part will be replaced by the following: 'Master Furriers Association of Quebec Inc.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec.June 30, 1956.42695-o Députés élus BUREAU DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS Québec, le 28 juin 1956.Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députés les can-dicats ci-après désignés, pour les représenter dans la nouvelle assemblée législative «le la province de Québec: Trois-Rivières L'honorable M.Maurice-L.Duplessis, avocat 240.rue Bonaventurc, Trois-Rivières.Montréal-Notre-Damk-de-Grâok Monsieur Paul Earl, agent de commission.5678.Avenue MacDonald, Montréal.Nicolet Monsieur J.-F.Camille Roy, cultivateur, Nicolet, P.Q.Le Président général des élections.42701-o FRANÇOIS DROUIN.C.R.Members Elected OFFICE OF THE CHIEF RETL'RNING-OFFICER Quebec, June 28th, 1956.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent the following electoral divisions in the new legislative assembly of the Province of Quebec: Three Rivers The Honourable Mr.Maurice-L.Duplessis, Advocate.240.Bonaventurc St., Trois-Rivières.Nontr b a l-Notr e-D am k-de-Grâce Mr.Paul Earl, Commission Agent.5678 Mac-Donald Avenue, Montreal.Nicolet Mr.J.-F.Camille Roy.Farmer.Nicolet, P.Q.FRANÇOIS DROLTN.Q.C., 4270l-o Chief Returning-Officcr. 2234 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.30 juin 1956, Tome 88, N° 26 BUREAU DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS .Québec, le 29 juin 1956, Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députés les- candidats ci-après désignés, pour les représenter dans la nouvelle assemblée législative de la province de Québec: Québec-Centre Monsieur Maurice Cloutier, directeur de funérailles.250^ d'Aiguillon.Québec.Matane L'honorable M.Onésime Gagnon, avocat, 22.Des Bernières, Québec.Saint-Sauveur Monsieur Francis Boudreau, comptable, 224, rue Ste-Catherine, Québec.Le Président général des élections, 42701-o FRANÇOIS DROUIN, C.R.OFFICE OF THE CHIEF RETURNING-OFFICER Quebec, June 29th, 1956.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent the following electoral divisions in the new legislative assembly of the Province of Quebec: Quebec-Centre Mr.Maurice Cloutier, Funeral Director, 25014 d'Aiguillon, Quebec.Matane The Honourable Mr.Onésime Gagnon, ad* vocate, 22, Des Bernières, Quebee.Saint-Sauveur Mr.Francis Boudreau, Accountant, 224, Ste.Catherine St., Quebec.FRANÇOIS DROUIN, Q.C., 42701-0 Chief Ret urn ing-Officer.Ministère des Finances Avis d'annulation d'enregistrement Attendu que \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", constituée en corporation en 1863 en conformité des dispositions du chapitre 52 des Statuts Consolidés du Haut-Canada 1859, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec auprès de la compangie du même nom \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", constituée en corporation par la Loi I Elizabeth II Chapitre 64, dont le siège social est situé à Stratford, province d'Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intermenu entre ces deux compagnies; Attendu que ladite compagnie s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", constituée en corporation en 1863, sont annulés; Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 19 juin 1956.Pour le Ministre des finances, de la Province, ( rEORGES LA FRANCE, 42691-26-2-o Surintendant des assurances.Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", enregistrée sous le numéro 572, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2520 qui l'autorise à effectuer dans la Province des contrats d'assurance relatifs aux gentes suivants: Incendie; Biens immobiliers: Bris de glace; Défectuosité d'extincteurs automotiques; Intempéries; Transport intérieur.Le siège social de la compagnie est situé à Stratford, Ontario.Department of Finance Notice of' Cancellation of Registration Whereas \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", incorporated in 1863 under the provisions of chapter 52 of the Consolidated Statutes of Upper Canada 1859, has reinsured all its business in the province of Quebec with the company of the same name*The Perth Mut ual Fire Insurance Company\", incorporated by Act I, Elizabeth II.Chapter 64, whose head office is situate in Stratford, Province of Ontario, according to a reinsurande agreement entered into by these two companies; Whereas this company has complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Therefore notice is hereby given that the license and certificate of registry of \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", incorporated in 1863, is cancelled.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 19th June 1956.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 42091-20-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"The Perth Mutual Fire Insurance Company\", registered under number 572, has obtained the license and certificate of registry number 2520 authorizing it to undertake in this Province contracts of insurance of the following classes: Fire; Inland transportation; Personal property; Real property; Sprinkler leakage; Weather.The bead office of the company is situate in Strafford, Ontario. Ql ÏEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.June 80th.1956, Vol.88.No.26 2235 La compagnie a nommé monsieur Victor Mongeon, 291 avenue Dufi'crin.Sherbrooke, son procureur dans la Province.Donné an bureau du Service des Assurances.Ministère des finances, le 19 juin 1956.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LA FRANCE, 42691-20-2-o , Surintendant des assurances.The company has appoint»! Mr.Victor Mongeon.291 Dufferin Avenue.Sherbrooke, its a attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 19lh of June 1956.For the Minister of Finance of the Province.GEORGES LAFRANCE, 42691-26-2-o Superintendent of Insurance.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BARREAU DE BEDFORD \u2014 BAR OF BEDFORD Candidat pour l'admission à l'étude du dhoit Candidate for the admission to the study ok law Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tRésidence Residence \t\t19\tGranby, P.Q.\t\t\t Sweetsburg, 22 juin 1950 \u2014 Sweetsburg June 9th, 1956.42690-o Le Secrétaire du Barreau de Bedford, BERNARD LÉGARÉ, Secretary of the Bar of Bedford.BARREAU DE ST-FRANÇOIS \u2014 BAR OF ST.FRANCIS Candidat pour l'admission à l'étude du droit Candidate for the admission to the study of law Nom\tPrénom\t\tRésidence\tCollège \u2014\t\u2014\tAge\t\u2014\t\u2014 Name\tSurname\t\tResidence\tCollege \t\t22\t\tSéminaire St-Charles Borromée, Sherbrooke, Université d'Ottawa.\t\t\t\t Sherbrooke, ce 23 juin 1950\u2014 Sherbrooke, June 23rd, 1950.42690-o Le Secrétaire du Barreau de St-François CHARLES LEBLANC,.Secretary of the Bar of St.Francis.BARREAU DES LAURENTIDES \u2014 BAR OF LAURENTIDES Candidat pour l'admission à l'étude du droit Candidatb for the admission- to the study of law Examens d'octobre 1966 \u2014 Examinations of October I960 Nom\tPrénom\t\tRésidence\tCollèges \t\u2014\tAge\t-\u2014\t\u2014 Name ,\tSurname\t\tResidence\tColleges \tClaude.\t21\t\tSéminaire St-Sacreinent, Collège Jean Brébeuf.\t\t\t\t Joliette, 26 juin 1950 \u2014 Joliette, June 26th, 1950.42G90-o Le Secrétaire du Barreau des Laurentides, MAURICE MAJEAU, Secretary of the Bar of Laurentides.Canada.Province de Québec.[L.S.] Proclamation GASPARD FAUTEUX Proclamation Canada, Province of Quebec.|L.S.| GASPARD FAUTEUX ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, «lu Canada et de ses God of the United Kingdom, Canada and Her 2236 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.SO juin 1956, Tome 88, N° 26 autres royaumes et territoires, clief du Commonwealth, défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: PROCLAMATION L\"Assistant-procureur ( A TTENDU que l'ho-génêral, / norahle ministre des C.E.cantin.\\ terres et forêts de Notre « province de Québec a fait préparer, sous sa direction, conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi 21 George V, chapitre 101.un plan et un livre de renvoi revisés d'une partie du canton de Dalibaire, comprenant les rangs VIII.IX et une partie «les rangs Y.VI, VII, X.XI et XII, division d'enregistrement de Matane; Attendu que ces plan et livre de renvoi révisés font maintenant partie des archives du département des terres et forêts, et qu'une copie exacte a été déposée au bureau de la division d'enregistrement de Matane; A ces causes, du consentement et de l'a vis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans l'arrêté en conseil N° 594, en date du 30 mai 1956, et conformément aux dispositions des articles 2174 et 2174A du Code civil, et du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi 21 George V.chapitre 101.Nous donnons avis du dépôt de ces plan et livre de renvoi revisés mentionnes ci-dessus au bureau de la division d'enregistrement qu'il appartient, lequel est désigné ci-dessus, et Nous fixons à la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, le jour auquel les dispositions du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi 21 George V, chapitre 104, deviendront en vigueur relativement à cette partie du canton de Dalibaire, comprenant les rangs VIII, IX et une partie des rangs V, VI, VII, X, XI et XII, division d'enregistrement de Matane; et Nous invitons toute personne intéressée, à peine de perdre la priorité conférée par la loi, à renouveler, dans l'année qui suit la date fixée ci-dessus, toutes les hypothèques affectant particulièrement aucun des lots mentionnés aux dits plan et livre de renvoi et non compris les hypothèques affectant tout le terrain subdivisé.De tout ce que dessus, tous Nos féaux .sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPART FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-sixième jour de juin en l'année mil neuf cent cinquante-six de l'ère chrétienne et de Notre Règne la cinquième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la province, 42675-0 JEAN BRUCHÉSI.other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth.Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Gkeetinc; : PROCLAMATION C.E.Caxtin, (TWHEREAS the Honou-Dcputy Attorney) » » rable the Minister of General.\\ Lands and Forests of Our ' Province has caused to be prepared under his supervision, in conformity with sub-paragraphe a of paragraph 1 of section 3 of the Act 21 George V, chapter 104, a revised plan and book of reference of a part of the township or Dalibaire, comprising ranges VIII, IX and part ofranges V.VI, VIL X, XI ami XII.of the Registry Division of Matane; Wiieheas the said revised plan and book of reference now form part of the archives of the Department of Lauds and Forests, and that exact copy as been deposited with the office of the Registry Division of Matane; Tiiekefoke, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in Order in Council No.594 dated May 30th.1950, and according to provisions of sections 2174 and 2174A of the Civil Code, and of sub-paragraph a of paragraph 1 of section 3 of the Act 21 George V, chapter 104.We give notice of the depositing of said revised plan and book of reference mentioned hereinabove with the office of the registry division to which it belongs, such as designated hereinabove; and We fix the date of publication of this proclamation in the Quebec Official Gazette, as the day on which the provisions of subparagraph c, paragraph 1 of section 3 of the Act 21 George V, chapter 104, shall come into force respecting that part of the township of Dalibaire, comprising ranges VIII, IX and a part of ranges V.VI, VII, X, XI and XII, registry division of Matane; and We invite any interested party, under penalty of losing the priority conferred by Law, to renew, within the year following the date fixed hereinabove, all the hypothecs particularly affecting any of the lots on the plans and books of reference and not including the hypothecs affecting all the subdivided land.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whekeof.We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trustv and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at our Government House in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this twenty-sixth day of June, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty-five and in fifth year of Our Reign.By command, JEAN BRUCHÉSI, 42675 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 30th, 1956, Vol.88, No.26 2237 Sièges sociaux AVIS OFFICIEL Le \"Conseil Sherbrooke, N°530, des Chevaliers de Colomb\" de Sherbrooke, P.Q.donne avis par les présentes qu'il possède son siège social à l'adresse ci-dessus indiquée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth IL ch.134, art.2a).Le .Grand Chavalier, LOUIS-PHILIPPE BROUSSEAU.Le Secrétaire Archiviste, 42683-0 MARCEL LABRIE.Club de Golf de Matane Inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Club de Golf de Matane Inc.*' constituée en corporation par lettres patentes en date du sept février mil neuf cent cinquante-six, a établi son siège social dans l'Édifice de la Gare, à l'extrémité ouest de la rue Soucy.dans la ville de Matane.A compter de la date du présent avis le dit bureau est considéré par la compagnie comme étant son principal bureau d'affaires de la compagnie.En foi de quoi j'ai signé à Matane.ce quatorzième jour de juin mil neuf cent cinquante-six.Club de Golf de Matane Inc.(Sceau) Par le Secrétaire.426S4-o CLÉMENT CÔTÉ.(P.G.11456-54) Homes & Gardens Inc.Règlement spécial N° 7 \"Sur motion dûment secondée,il est unanimement\" résolu : Que le règlement spécial No.7 de la compagnie soit et est par les présentes adopté comme suit: Que le siège social de la compagnie soit et est par les présentes changé et transporté du numéro 2081 de la rue Aylmer à Montréal, au numéro 415 «le la rue Bourgogne à Chambly, P.Q.\" Copie Certifiée.Le Secrétaire, 426S5-0 JOS.STE-MARIE.Ludger Lepage & Fils Ltée Avis est donné que la Compagnie I.udgcr Lepage & Fils Ltée, constituée en corporation par îettres patentes, en date du 13 janvier 1951 et ayant son siège social à St-Félicien, a établi son bureau principal au numéro 52.boulevard Sacré-Coeur.A compter de la date du présent avis, le dit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à' St-Félicien, ce 30 mai 1956.Le Président.42686-0' LUDGER LEPAGE.(P.G.10311-50) Morin Machine Works Ltd.Règlement N° 4 \"Qu'il soit et il est.par les présentes, décrété comme un règlement de Morin Machine Works Head Offices OFFICIAL NOTICE The \"Council Sherbrooke.Xo.530 of the Knights of Columbus\", of Sherbrooke.P.Q.hereby gives notice that its head office is located at the ahovementioned address and that it is availing itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Quebec (1-2 Elizabeth II, chap.134.see.2a).LOUIS-PHILIPPE BROUSSEAU, Grand Knight.MARCEL LABRIE.426S3 Recording-Secret a ry.Club de Golf de Matane Inc.Notice is hereby given that the company \"Club de (iolf de.Matane Inc.\".constituted as a corporation by letters patent under date of the seventh day of February, one thousand nine hundred and fifty-six.has established its head office in the Railway Station Building, at the far end of Soucy Street, in the town of Matane.As from the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.In witness whereof I have signed at Matane, this fourteenth day of June, one thousand nine hundred and fifty-six.Club de Golf de Matane Inc.(Seal) .Per: CLÉMENT CÔTÉ, 42084 Secretary.(A.G.I H56-54) Homes & Gardens Inc.Special By-La ir No.7 \"Upon motion duly seconded, it was unanimously resolved : That Special By-law No.7 of the * company.Dated at Montreal, thi < 1st day of February, 1956.(Seal) Terrebonne Villas Inc., CLOVIS ARES.42689-0 President.Notice is hereby given that \"Chambre de Finance Inc.\u2014 Chamber of Finance Inc.\", incorporated by letters patent dated March 19, 1956, an«Lhaving its head office, in the city of Quebec, has established its office at 990 des Érables.From and after the «late of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Quebec, this 2nd dav of April 1956.JULIEN ( HOI INARD.42702-O Secretary.Notice is hereby given that the company \"Pierre Valcour Entreprises Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act dated the ninth day of the month of March of the year one thousand nine hundred ami fifty-six, and having its main office in the Province of Quebec, at Montreal, has established its office at number 188a Dor«*hester boulevanl East, at Montreal.From ami after the «late of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this twenty-sixth «lay of June of the year one thousand nine humlred ami fifty-six.(Seal) ROLAND MILETTE, imtarv at Montreal, 42704-O Attorney.Notic«' is hereby given that Pacific Atlantic Canadian Investment Company Ltd.incorporated originally under name of Second Cana«iian International Investment Company, Limited by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.June 30th.1956, Vol.88, No.26 2239 pany Limited, par lettres patentes en date du letters patent dated 22nd February, 1937 and 22 février 1937 et ayant son siège social en les having its head ofliee in the city and district of cité et district de Montréal, a transporté son Montreal has moved its head office from 231 dit .bureau de 231 ouest, rtie St-.Iacques à 275 St.James Street West to 275 St.James Street ouest, rue St-Jacques le 9 mai 1956.West on the 9th day of May, 1956.Daté à Montréal, Ce 15e jour de juin 1956.Dated at Montreal, this 15th dav of June 1050.(Sceau) Le Secrétaire, (Seal) G.V.RYCKMAN, 42713 G.Y.RYCKMAN.42713-o Secretary.Vente \u2014 Loi de faillite Canada, province de Québec, district de Joliette, Cour Supérieure (En matière de faillite) N° 575 in re: Joseph St-Amour, autrefois hôtel-lier, et maintenant bûcheron, de Notre-Dame de la Merci, district de Joliette.débiteur.Avis est par les présentes donné que M ERCRE-DI, le PREMIER jour d'AOÛT 1956.à ONZE heures de Pavant-midi, à la porte de l'église paroissiale de Notre-Dame de la Merci.Co.Montcalm, district de Joliette, seront vendus, par encan public, au plus haut et dernier enchérisseur, avec effet du décret, les immeubles suivants cédés par le débiteur, en cette cause, savoir: 1° \"Un lot «le terre situé dans la paroisse de Notre-Dame de la Merci, district «le Joliette, connu et désigné comme étant le numéro soixante du bloc A, «lu ca«lastre officiel du canton Chilton, avec toutes lés bâtisses dessus construites.\" 2° \"Le lot numéro 10 du 9ième rang du (Piastre officiel «lu Canton Chilton.\" 3° \"Le lot numéro 7 «lu lOièine rang du Cadastre officiel du canton Chilton.\" 4° \"Le l«)t numéro 41 du 5ième rang du cadastre officiel du canton Chilton.Chaque immeuble sera vendu séparément.Il sera exigé «le tout offrant ou enchérisseur, sur chaque offre ou enchère, sur l'immeuble en premier lieu désigné, un dépôt «le S90.00; sur le 2ième, un dépôt de $25.00; sur le 3ième, un dépôt «le $25.00; et sur le 4ième, un «lépôt de 815.00.Les ac«m''reurs devront prendre les immeubles dans l'état où ils sont présentement, sans aucune garantie, sauf celle «les faits personnels du syndic.Cette vente faite d'après les articles 55 et suivants de la Loi de Faillite équivaut à une vente faite par le Shérif.21 juin 1956.Le Syndic-autorisé.PAUL JOLICOEUR.197, Saint-Charles Borromée Nord, 32 Place Bourget Nord, Joliette.42692-26-2-o Sale \u2014 Bakrupcy Act Canada.Province of Quebec, district of Joliette.Superior Court (Sitting in bankruptcy) No.575.In re: Joseph St-Amour, heretofore hotel-keeper, and presently lumber-jack, of Notre-Dame de la Merci, district of Joliette, debtor.Notice is hereby given liy these present that on WEDNESDAY, the FIRST day of AUGUST, 1956, at ELEVENTH o'clock in the forenoon, at the parochial church door of Notre-Dame «le la Merci, Co.Montcalm, district of Joliette, shall be sold, by public auction, to the highest bidder, having the effect of a sheriff's sale, the following immoveables ce«le«l by the debtor, int his case, to wit: 1.\"A lot of land situated in the parish of Notre-Dame de la Merci, «listrict of Joliette, known and «lesignated as being number sixty of Block A, of the official ca«lastre of Chilton township, with all the buildings thereon erected.\" 2.Lot number 10 of the 9th range of the official cadastre of Children township.\" 3.\"Lot number 7 of the 10th range of the official cadastre of Chilton township.\" 4.\"Lot number 41 of the 5th range of the official cadastre of Chilton township.Each immoveable shall be sol«l separately.There shall be exacted from each bidder, for each offer or bid.upon the immoveable designated in the first instance, a deposit of 890.00; upon the 2n«l, a deposit of 825.00; upon the 3rd, a deposit of 825.00: ami upon the 4th.a deposit of 815.00.Purchasers shall take the immoveables in the state in which they are to be found presently, without any guarantee, except that of the personal effects of the Trustee.This sale made according to sections 55 and following of the Bankruptcy Act is equivalent to a sale made by Sheriff.June 21.1956.PALL JOLICOEUR.Authorized Trustee.197, Saint-Charles Borromée North.32 North Bourget Place.Joliette.42092-26-2 Vente pour taxes Province de Québec Ville de Laval-Ouest Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier «le la ville «le Laval-Ouest que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville, 2-16e Avenue dans ladite ville.VENDREDI, le VINGT-SEPT JUILLET' 1956 à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement îles taxes municipales et scolaires ainsi Sale for Taxes Province of Quebec x\u2014 Town of Laval-West Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the town of Laval-West that the hereinafter described immoveables will be sold by public auction at the city hall, 2 - 16th Avenue in the sai«l town on FRIDAY, the TWENTY-SEVENTH «lay of JULY, 1956 at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of municipal and school 2240 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.SO juin 1950, Tome 88, A'° 26 que des intérêts courus et des frais, à moins que taxes with accrued interest, and costs incurred ces taxes, intérêt et frais ne soient payés avant thereon, unless the said taxes, interest and costs la vente: be paid before the sale: \tN° de cadastre et\tTaxes\tTaxes\t Nom des propriétaires\tN° de subdivisions\tscolaires\tmunc.\t \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tTotal Name of property owners\tNo.of cadastre\t.School\tMunie.\t \tA subdivisions\ttaxes\ttaxes\t \t180 \u2014 187 à-to 191\t$35.02\t$164.57\t$200.49 \t214 à-to 218.\t\t\t \t182 \u2014373 à-to 377.\t28.56\t53.90\t82.46 MM.-Mr.Archambault, Raoul de M.Prévost R.\t\t\t\t Painchaud, Zachée Langlais & Alp.Ferrou.\t186 \u2014 Ile-Isle 452.\t7.90\t25.18\t33.08 Mme-Mre.Hyman Ruckenstein.\t182 \u2014 77 à-to 78.\t30.06\t127.65\t157.71 Les immeubles susdits sont tous décrits aux plan The above immoveables are all described on the officiel et livre de renvoi de la paroisse de Sainte-Rose.Official Plan and Book of Reference of the Parish of St.Rose.Donné en la ville de Laval-Ouest, ce 22c jour Given at Laval-West, this 22nd day of June de juin 1050.1956.Publié dans la Gazelle officielle de Québec.To be published in the Quebec Official Gazette, La Presse et le Star, les 30 juin et 7 juillet 1950.La Presse and the Star on June 30th, and July 7th, 1056.Le Secrétaire-trésorier, J.GALARNEAU, 42693-26-2-0 J.GALARNEAU.42693-26-2-0 Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.IBERVILLE Canada \u2014 Province de Québec District d'Iberville Cour Supérieure, / T-JENRY MORGAN & N° 7878
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.