Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 février 1957, samedi 23 (no 8)
[" Tome 89, N° 8 691 Vol.89, No.8 \t\t mi\ti\t \t1\t T\t\tt Drapeau de la province de Québec adopté pu 'a Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by ihe Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 23 février 1957 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci .est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5 L'abonnement, la vente de documents, etc , sont strictement payables d'avance.t 6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, February 23rd, 1957 * ¦ ¦¦ ¦ \u2014\" NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 692 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° 8 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi) le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes (l'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes nu pouce, soit 2G6 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui dp l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thura.day, provided that none of the three last da\\ s of the week be a holiday.In the latter case-, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsemient edition.Moreover the Queen's Printer is en I i tied to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for botli parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published hut once arc followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502-1-52 Lettres patentes (P.G.J 0031-57) Allied Equipment & Supply Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1957, constituant en corporation: Raphaël Maurice Phillips, administrateur, Samuel J.Smiley, avocat, tous deux de Montréal et Gertrude Gagnon Kay, ménagère et marchande, épouse séparée de biens de Alex Kay et dûment autorisée par ce dernier, de la ville de Dorval, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le négoce et.le commerce de pièce moulées de carbone et d'alliages d'acier, spécialités connexes aux locomotives et wagons de chemin de fer et autres machines, outillage et accessoires se rapportant à iceux, sous le nom de \"Allied Equipment & Supply Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Letters Patent (A.G.10031-57) Allied Equipment & Supply Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1957, incorporating: Raphaël Maurice Phillips, executive, Samuel J.Smiley, advocate, both of Montreal, and Gertrude Gagnon Kay, housewife and marchande, wife separate as to property of Alex Kay, and duly authorized by him, of the town of Dorval, for the following purposes: To manufacture and deal in and with carbon and alloy steel castings, locomotive and railroad car specialties and other machinery, equipment arid accessories thereof, under the name of \"Allied Equipment & Supply Inc.'*; with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 693 Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.13986-56) Bay Electric Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1957, constituant en corporation: Boris Garmaisc, avocat, Alva Phyllis Boyd, secrétaire, fille majeure tous deux de Montréal, et Lyon Levine, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme électriciens; et celui de marchands de toutes sortes de marchandises électriques, sous le nom de \"Bay Electric Company Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.11219-56) Beatrice Pines Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1956, constituant en corporation: Clarence Reuben Gross, avocat, Sarah .Miller, sténographe, tous deux de Montréal et Samuel David Rudcnko, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce de vêtements et lingerie pour dames et enfants, sous le nom de \"Beatrice Pines Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.10005-57) Belga Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des-compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres-patentes, en date du huit janvier 1957, constituant en corporation: François Van Roey, importateur, Angèlc Mas-stirl, ménagère, épouse séparée de biens dudit François Van Roey, et Françoise Van Roey, professeur, épouse séparée de biens de Gilles Rouv, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'articles et marchandises faits, en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, nylon, plastique, fourrure, textile, verre, et leurs sous-produits, de merceries, de produits comestibles, chimiques et de beauté, sous le nom de \"Belga Inc.\", avec un Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13986-56) Bay Electric Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1957, incorporating: Boris Garmaise, advocate, Alva Phyllis Boyd, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and Lyon Levine, advocate, of Westmount, for the following purposes: To carry on business as electricians; to deal in electrical merchandise of all kinds, under the name of \"Bay Electric Company Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14219-56) Beatrice Pines Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1956, incorporating: Clarence Reuben Gross, advocate, Sarah Miller, stenographer, both of Montreal, and Samuel David Rudcnko, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, for the following purposes: To manufacture and deal in ladies' clothing and lingerie, under the name of \"Beatrice Pines Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10005-57) Belga Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' ActK letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1957, incorporating: François Van Roey, importer, An gèle Massart, housewife, wife separate as to property of the said François Van Roey, and Françoise Van Roey, professor, wife separate as to property of Gilles Roux, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, métalloïde, nylon, plastic, fur, textile, glass, and their by-products, in small wares, edible products, chemical and beauty products, under the name of \"Belga Inc.\", with 01)4 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 février 1957, Tome 89, N° 8 capital total de 820,000, divisé en 2,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3G19, rue Saint-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1057.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14100-56) CurdinnI Holdings Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept décembre 1956, constituant en corporation : Hynian Solomon, avocat, de Ville Mont Royal, Louis Feigenbaum, avocat, Morris Shuter, gérant de bureau, tous deux de St-Laurcnt, Perry Meyer, Morris Cheikelson, tous deux avocats, Jacqueline Ormos, secrétaire, tous trois de Montréal, et Nathaniel L.Levy, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Cardinal Holdings Corp.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 4,000 actions de SI 0 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.- Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.10156-57) Central Bachelor Mines Corp.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 1957, constituant en corporation: David Henry Holland, avocat, de St-Lambert, Clifford George Meek.Guy Ambrose Miller, tous deux teneurs de livres, de Montréal, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, de Brucy et Charles Eric Humphrey, teneur de livres, de Verdun, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier', sous le nom de \"Central Bachelor Mines Corp.\" (No Personal Liability), avec un capital total de 85,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions d'une valeur au pair de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14066-56) n.c.Fuoco Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un décembre 1956, constituant en corporation: Jack Lightstone, Marvin Riback, a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of 810 each.The head office of the company will he at 3619, Saint-Denis street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14106-56) Cardinal Holdings Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of December, 1956, incorporating: Ilyrnan Solomon, advocate, of the town of Mount Royal, Louis Feigenbaum, advocate, Morris Shuter, office manager, both of St.Laurent, Perry Meyer, Morris Chaikelson, both advocates, Jacqueline Ormos, secretary, all three of Montreal, and Nathaniel L.Levy, advocate, of Westmount, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Cardinal Holdings Corp.\", with a total capital stock of SIO.OOO, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-scventh day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10156-57) Central Bachelor Mines Corp.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1957, incorporating: David Henry Holland, advocate, of St.Lambert, Clifford George Meek, Guy Ambrose Miller, both bookkeepers, of Montreal, Cecil Bruce Cooke, secretary, of Brucy, and Charles Eric Humphrey, bookkeeper, of Verdun, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Central Bachelor Mines Corp.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the a-mount of the price paid or agreed to be paid to the company for-its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district ef Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14066-56) * c.Fuoco Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December, 1956, incorporating: Jack Lightstone, Marvin Riback, both advocates, and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 695 tous deux avocats et Elie M.Solomon, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrain-, de construction et d'amélioration, sous le nom «le \"C.Fuoco Inc.\", avec un capital total de $10,000, divise en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 41351 P.FRENETTE.(P.G.11165-56) Champ de Lys Café Inc.Avis est donnjé qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1957, constituant en corporation: Xicholas-Demetrius Demctelin, marchand, Sophie Glczos, ménagère, épouse contractuclle-ment séparée de biens dudit Nicholas-Demetrius Demetelin, tous deux d'Outremont, Jean-Paul Boisjoly, comptable, et Georgette Gagné, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit .lean-Paul Boisjoly, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, hôteliers, pourvoyeurs, pâtissiers, épiciers et charcutiers, sous le nom de \"Champ de Lys Café Inc.\", avec un capital total de S50.000, divisé en 500 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.1-1037-56) C.M.& T.Contractors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze décembre 1956, constituant en corporation: Daniel Kingstone, étudiant, Judith.Pink, sténographe, fille majeure, Samuel Godins-ky, avocat, Robert DeLuca et Irwin Sicgel, manufacturiers, tous de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des habits et vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"CM.& T.Contractors Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 3,000 ac-ions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victo-naville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 p.FRENETTE.(P-G.14220-56) Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée Charlevoix Saguenay Navigation Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première Partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Elie M.Solomon, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"C.Fuoco Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14165-56) Champ de Lys Café Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January.1957, incorporating: Nicholas-Demetrius Demetelin, merchant, Sophie Glczos, housewife, wife contractually separate as to property of the said Nicholas-Demetrius Demetelin, both of Outremont, Jean-Paul Boisjoly, accountant, and Georgette Gagné, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean-Paul Boisjoly, both of Montreal, for the following: purposes: To carry on business as restaurant-keepers, hotel-keepers, purveyors, confectioners, grocers and delicatessens, under the name of \"Champ de Lys Café Lie\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14037-56) C.M.& T.Contractors Ltd.Notice is hereby -given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of December, 1956, incorporating: Daniel Kingstone, student, Judith Fink, stenographer, spinster, Samuel Godinsky, barrister, Robert DeLuca and Irwin Siegel, manufacturers, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"CM.& T.Contractors Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 350 preferred shares having a par value of $100 each and into 3,000 common shares having a par value of $5 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14220-56) Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée Charlevoix Saguenay Navigation Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 696 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 février 1957, Tome 89, N° 8 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lett rcs patentes, en date du vingt-huit décembre 1956, constituant en corporation: André Gagnon, Gilles de Billy, Claude Gagnon, avocats, Charlotte Risi, secrétaire, tous quatre de Sillery et Lucilc Rioux, secrétaire, de Québec, pour les objets suivants: Posséder et gérer, noliser, prêter et exploiter des bateaux à vapeur, à moteur, diesel et autres, sous le nom de \"Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay ' Limitée \u2014 Charlevoix Saguenay Navigation Company Limited\", avec un capital total de 850,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 8,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 17 rue St-Jacques, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14085-56) Converters Children's Wear Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 195G, constituant en corporation : Shah ecu Boushy, aussi connu comme Eugène Beauchamp, Joseph Beauchamp et Raymond Beauchamp, tous trois manufacturiers, de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements d'enfants; transiger les affaires d'une compagnie de terrrains, de construction et de développement, sous le nom de \"Converters Children's Wear Co.Ltd.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de SI00 chacune et 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1956.¦* L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.13933-56) D.& C.Electric Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1957, constituant en corporation: Jacques Décary, de Dorval, Georges Bilodeau, de Montréal-Nord, Bernard Bilodeau, de Westmount, et Rhéal Brunet, de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et électriciens; exercer le commerce de matériaux de construction, d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de \"D.& Cr Electric Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1956, incorporating: André Gagnon, Gilles de Billy, Claude Gagnon, advocates, Charlotte Risi, secretary, all four of Sillery, and Lucile Rioux, secretary, of Quebec, for the following purposes: To own and control, charter, lease and operate, steam, motor, diesel and other ships, under the name of \"Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée \u2014 Charlevoix Saguenay Navigation Company Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and into 8,000 preferred shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at 17, St.James Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14085-56) Converters Children's Wear Co.Ltd.Notice is hereby given thar under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1956, incorporating: Shabeen Boushy, also known as Eugène Beauchamp, Joseph Beauchamp and Raymond Beauchamp, all three manufacturers, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in children's wear; to carry on the business of a land, construction and development company, under the name of \"Converters Children's Wear Co.Ltd.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,500 common shares of $100 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13933-56) D.& C.Electric Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1957, incorporating: Jacques Décary, of Dorval, Georges Bilodeau, of Montreal-North, Bernard Bilodeau, of Westmount, and Rhéal Brunet, of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as general contractors in construction and as electricians; to operate a business dealing in building materials, electrical accessories and appliances, under the name of \"D.& C.Electric Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal-North, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 697 (P.G.13889-56) Deacon Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt décembre 1956, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, tous deux avocats et John Hamilton, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Deacon Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14097-56) Dcshaics Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1957, constituant en corporation: Elphège Deshaies, garagiste, Georgette Lambert, ménagère, épouse contractuellcment séparée de biens dudit Elphège DeshaieS, tous deux du Cap-de-la-Madeleine, et Marc Maynard, comptable, des Trois-Rivièrcs, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles; faire affaires comme garagistes et quincailliers, sous le nom de \"Deshaies Automobiles Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux T rois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivièrcs.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.10181-57) Desjardins Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1957, constituant en corporation: Jean-Guy Desjardins, administrateur d'affaires, de Sillery, Jean Gagné, agent d'immeubles, Rosario Man seau, administrateur d'affaires, Rose-Aimée Fleury, comptable, et Thérèse Tardif, sténographe, tous quatre de Québec, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'automobiles et accessoires s'y rapportant; et celui de garagistes, sous le nom de \"Desjardins Automobiles Inc.\", avec un cpital total de $160,000, divisé en 11,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Les Ecureuils, conté de Portneuf, district judiciaire «le Québec., Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, -44354 P.FRENETTE.(A.G.13889-56) Deacon Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1956, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, both advocates, and John Hamilton, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Deacon Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of the par value of $10 each and into 3,600 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14097-56) Deshaies Automobiles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1957, incorporating: Elphège Deshaies, garage-keeper,- Georgette Lambert, housewife, contractually separate as to property of the said Elphège Deshaies, both of Cap-de-la-Madeleine, and Marc Maynard, accountant, of Trois-Riviè-res, for the following purposes: To carry on an industry and commerce dealing in automobiles; to carry on business as garage-keepers and hardware dealers, under the name of \"Deshaies Automobiles Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivièrcs, judicial district of Trois-Rivièrcs.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January; 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10181-57) Desjardins Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1957, incorporating: Jean-Guy Desjardins, business executive, of Sillery, Jean Gagné, real estate agent, Rosario Manseau, business executive, Rose-Aimée Fleury, accountant, and Thérèse Tardif, stenographer, all four of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles and accessories connected therewith; to carry on business as garage keepers, under the name of \"Desjardins Automobiles Inc.\", with a total capital stock of $160,000, divided into 11,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at Les Écureuils, county of Portneuf, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of Januarv, 1957.P.FRENETTE, 44354-o Acting Dep*uty Attorney General. 698 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 février 1957, Tome 89, N° 8 (P.G.14104-56) Desmnrais & Frère Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1957, constituant en corporation: Claude Desmarais, imprimeur, Marguerite Bo-nenfant Desmarais, ménagère, épouse séparée de bjens dudit Claude Desmarais, Gérard Desmarais, imprimeur, et Denise Gervais Desmarais, ménagère, épouse séparée de biens dudit Gérard Desmarais, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs; exercer l'industrie et le commerce de gravures, images, peintures, dessins, albums, cartes de souhaits et autres objets scmblabes, sous le nom de \"Desmarais & Frère Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions communes de.$100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur' général, le cinq janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(A.G.14104-56) Desmarais & Frère Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1957, incorporating: Claude Desmarais, printer, Marguerite Boncnfant Dcsmarais, housewife, wife separate as to property of the said Claude Dcsmarais, Gérard Desmarais, printer, and Denise Gervais Desmarais, housewie, wife separate as to property of the said Gérard Desmarais, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as printers; to operate a business dealing in engravings, pictures, drawings, albums, greeting cards and other similar objects, under the name of \"Dcsmarais & Frère Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13977-56) Drummond Auto Electric Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date, du huit janvier 1957, constituant en corporation: Fernand Nadcau, garagiste, Yolande Roussel Nadeau, ménagère, épouse commune en biens dudit Fernand Nadeau, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Léo-Paul Nadeau, garagiste, tous de Drummond ville, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et de leurs accessoires; faire affaires comme garagistes et quincailliers, sous le nom de \"Drummond Auto Electric Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drum-mondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.10051-57) Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1957, constituant en corporation: Jacques de Billy, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Claire Miquelon, secrétaire, fille majeure, tous deux de Québec, André Gagnon, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Charlotte Risi, secrétaire, fille majeure, tous deux de Sillery et Huguette Morin, secrétaire, fille majeure, de Lauzon pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Esker Quebec Mines Limited\" (A.G.13977-56) Drummond Auto Electric Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1957, incorporating: Fernand Nadeau, garage-keeper, Yolande Roussel Nadeau, housewife, wife common as to property of the said Fernand Nadcau, and duly authorized by him for these present purposes, and Léo-Paul Nadeau, garage-keeper, all of Drummondvillc, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in automobiles and their accessories; to carry on business as garage-keepers and hardware dealers under the name of \"Drummond Auto Electric Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of a nominal value of $100 each and into 500 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Drummondvillc, judicial district of Arthahaska.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10051-57) Esker Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1957, incorporating: Jacques de Billy, advocate and Queen's Counsel, Claire Miqttelon, secretary, spinster, both of Quebec, André Gagnon, advocate and Queen's Counsel, Charlotte Risi, secretary, spinster, both of Sillery, and Huguette Morin, secretary, spinster, of Lauzon, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Esker Quebec Mines Limited\" (No Personal Liability). QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 699 (No Personal Liability), avec un capital total de$ 10,000, divise en 40,000 actions de SI chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, ! 1354 P.FRENETTE.(P.G.13928-56) Farman Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un décembre 1956, constituant en corporation: Harry Pinker, avocat, de Montréal-Ouest, Nathaniel Liebman, notaire et Mortiner Smith, commis, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Farman Investment Lie\", avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14191-56) Fibercut Appliances Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1956, constituant en corporation: Roland-Gérard Lefrançois, Jean Goulet et Jacques Lalonde, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de produits chimiques, minéraux chimiques, produits, dispositifs et choses composés en totalité ou en partie de matières fibreuses-d'aucune sorte, sous le nom de \"Fibercut Appliances Limited\", avec un capital-actions divisé en 4,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14019-56) Fox Brothers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt décembre 1956, constituant en corporation : Harry Fox, vendeur, Samuel Fox, graveur a 1 eau-forte, Micheal Fox, gérant de production, tous trois de Montréal, David Fox, preneur de vues et Oscar Fox, gérant de production, tous deux d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs et éditeurs, sous le nom de \"Fox Brothers Ltd.\", avec un with a.total capital stock of $40,000, divided into 40,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.¦ Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13928-56) Farman Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December, 1966, incorporating: Harry Pinker, advocate, of Montreal West, Nathaniel Liebman, notary, and Mortimer Smith, clerk, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Farman Investment Lie\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14191-56) Fibercut Appliances Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1956, incorporating: Roland-Gérard Lefrançois, Jean Goulet and Jacques Lalonde, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in chemicals, chemical minerals, products, appliances and things composed in whole or in part of fibrous materials of any kind, under the name of \"Fibercut Appliances Limited\", with a capital stock divided into 4,000 shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14019-56) Fox Brothers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1956, incorporating: Harry Fox, salesman, Samuel Fox, etcher, Micheal Fox, production manager, all three of Montreal, David Fox, camera man, and Oscar Fox; production manager, both of Outremont, for the following purposes: To carry on business as printers and publishers, under the name of \"Fox Brothers Ltd.\", with a 700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Vome 89, N° 8 capital total de $100,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14135-56) Garage Idéal Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1957, constituant en corporation: Mme Médora Benoit, veuve de Eusèbe Gaudctte, ménagère, Marcel Gaudette, garagiste, et Gaston Gaudette, marchand, tous de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles; faire affaires comme garagistes et quincailliers, sous le nom de \"Garage Idéal Incorporée\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions communes de $100 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3140, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.10076-57) Garage Légaré & Frère Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1957, constituant en corporation: Richard Légaré, Conrad Légaré, garagistes, et Béatrice Boivin Légaré, rentière, épouse contrac-tuellement séparée de biens dudit Richard Légaré, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Cbarlesbourg, pour les objets suivants : Exercer l'industrie et le commerce d'automi-biles; faire affaires comme garagistes et restaurateurs, sous le nom de \"Garage Légaré & Frère Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Charles-bourg, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14151-56) Graphie Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1956, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Leon Rosentzveig, avocat, de Montréal et Manuel Shacter, avocat, de Dorval, pour les objets_suivants: total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14135-56) Garage Idéal Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1957, incorporating: Mrs.Médina Benoit, widow of Eusèbe Gaudette, housewife, Marcel Gaudctte, garage-keeper, and Gaston Gaudette, merchant, all of Saint-Hyacinthe, To carry on an industry and business dealing in automobiles; to carry on business as garage-keepers and hardware dealers, under the name of \"Garage Idéal Incorporée\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of $100 each and into 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 3140 Dessaulles St., Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10076-57) Garage Légaré & Frerc Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieu tenant-Go vernor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1957, incorporating: Richard Légaré, Conrad ^Légaré, garage-keepers, and Béatrice Boivin Légaré, annuitant, wife contractually separate as to property of the said Richard Légaré, and duly authorized by him for these present purposes, al of Cbarlesbourg, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in automobiles; to carry on business as garage-keepers and restaurant-keepers, under the name of \"Garage Légaré & Frère Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Cbarlesbourg, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14151-56) Graphic Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1956, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen s Counsel, of Westmount, Leo Rosentzveig, advocate, of Montreal, and Manuel Shacter, advocate, of Dorval, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 701 Exercer le commerce comme imprimeurs et éditeurs, sous le nom de \"Graphie Industries Ltd.\", avec un capital total de §100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 6,000 actions privilégiées dé $10 chacune.* Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.P.G.13959-56) H.Blanchctte Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1956, constituant ¦ en corporation: Hervé Blanchctte, industriel, Hu-ghette Blanchctte, ménagère, célibataire, Anita Blanchctte, ménagère, épouse séparée de biens de Jean-Paul Boivert, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des Trois-Rivièrcs, pour les-objets suivants: Exercer le commerce de fer ornemental et de produits métalliques, sous le nom de \"H.Blanchctte Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de compagnie sera aux Trois-Rivières, district1 judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, ! 1354-0 P.FRENETTE.(P.G.13S95-56) Héroux & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un décembre 1956, constituant en corporation: J.-Antonio Héroux, industriel, Jean-Louis Héroux, contremaître, et Gilles Héroux, gérant, tous de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du bois et de ses sous-produits, ainsi que de matériaux de construction; faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Héroux & Fils Inc.\", avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 1,400 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4, rue Langlois, Terrebonne, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14051-56) Hôpital Général Fleury, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date, du vingt-trois janvier 1957, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph-Alcide Di-onne, médecin, Cécile Dionne Landry ménagère, épouse séparée de biens de Jean Baptiste Lan- To carry on business as printers and publishers, under the name of \"Graphic Industries Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 4,000 common shares of $10 each and into 6,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13959-56) H.Blanchctte Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1956, incorporating: Hervé Blanchctte, industrialist, Hughette Blanchctte, housekeeper, bachelor, Anita Blanchette, housewife, wife separate as to property of Jean-Paul Boisvert, and duly authorized by him for these present purposes, all of Trois-Rivières, for the following purposes: To operate a business dealing in ornemental iron and metal products, under the name of \"H.Blanchette Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and into 10,000 preferred shares of a par value of SI each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.» _ (A.G.13895-56) Héroux & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December, 1956, incorporating: J.Antonio Héroux, industrialist, Jean Louis Héroux, foreman, and Gilles Héroux, manager, all of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of and deal in lumber and the by-products thereof, as well as building materials and operate an general contractors, under the name of \"Héroux & Fils Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 shares without nominal or par value and 1,400 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at 4 Langlois Street, Terrebonne, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14051-56) Hôpital Général Fleury, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of January, 1957, to incorporate as a corporation without share capital : Joseph Alcide Dionne, physician, Cécile Dionne Landry, housewife, wife separate as to property of Jean Baptiste 702 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° 8 dry Gabrielle Dionne, institutrice, fille majeure usant de ses droits, Jehan Perdriau, avocat, tous de Montréal, et Robert Dionne, courtier en assurances, de Rivière-du-Loup, pour les objets suivants: Administrer et développer un hôpital général avec toutes les œuvres et tous les services connexes, sous le nom de \"Hôpital Général Fleury, Inc.\".Lemontant auquel sont limites les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 810,000,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14187-56) Jacques Cartier Cie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept décembre 1956, constituant en corporation: Jean-Pierre Pouliot, manufacturier, Fernande Racine Pouliot, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean-Pierre Pouliot, de Sillery, et Raymond Julien, comptable, de Saint-Augustin, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de balais et d'articles du même genre, sous le nom de \"Jacques Cartier Cie Lie\", avec un capital total de $50,000, divisé en 400 actions communes d'une valeur au pair de Si 00 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera 644, rue Dollard, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.13749-56) John Y.Stanfield Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1956, constituant en corporation: John Yorston Stanfield, agent industriel, de Westmount, James Gibb Stewart, avocat, du village de Como et Mildred Mullins secrétaire, fille majeure, usant de ses droits, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de distributeurs d'outillage industriel, d'unités de développement d'énergie motrice par la vapeur, accessoires de chauffage et de ventilation et dispositifs à la vapeur, sous le nom de \"John Y.Stanfield Company Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 8,000 actions d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1539 rue Crescent, suite No.2, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14189-66) Joseph-Antoine Santerre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi^des compagnies de Québec, il a Landry, Gabrielle Dionne, teacher of full age of majority making use of hers rights; Jehan Perdriau, advocate, all of Montreal, and Robert Dionne, insurance broker, of Rivicrc-du-Loup, for the following purposes: To manage and operate a general hospital with all works and services connected therewith under the name of \"Hôpital Général Fleury, Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 810,000,000.The head office of the the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third dav of January, 1957.P.FRENE1TE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14187-56) Jacques Cartier Cie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of December, 1956, incorporating: Jean-Pierre Pouliot, manufacturer, Fernande Racine Pouliot, housewife, wife separate as to property of the said Jean-Pierre Pouliot, of Sillery, and Raymond Julien, accountant, of Saint Augustin, for the following purposes: To carry on the busujess of and deal in;brooms and articles of the samePnaturc and kind, under the name of \"Jacques Cartier Cic Inc.\", with a total capital stock of S50.000, divided into 400 common shares of a par value of 8100 each and 100 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at 644 Dollard Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13749-56) John Y.Stanfield Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1956, incorporating: John Yorston Stanfield, manufacturers' agent, of Westmount, James Gibb Stewart, advocate, of the village of Como, and Mildred Mullins, secretary, spinsters use of his rights, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of distributors of industrial equipment, steam power plant equipment, heating and ventilating equipment and steam specialties, under the name of \"John Y.Stanfield Company Ltd.\", with a total capital \u2022 stock of S40,000, divided into 8,000 shares of a par value of 85 each.The head office of the company will be at 1539, Crescent Street, Suite No.2, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14189-56) Joseph-Antoine Santerre Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February SSrd, 1957, Vol 89, No.8 703 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept décembre 1956, constituant en corporation: Mme Joseph-Antoine Santerre, ménagère, épouse de Joseph-Antoine Santerre, Joseph-Antoine Santerre, Rosaire Santerre, Jean IJearclunans Santerre, tous quatre de Baie-des-Sables, Léon Santerre, Benoit Santerre, tous deux de Mont-Joli, Grégoire Santerre, de Matane, et Gamier Santerre, de Rimouski, tous commerçants, pour les objets suivants: Exercer le commerce de gros et de détail d'articles vendus dans les magasins à rayons, d'épicerie, de grains, farine et provisions, et faire affaires comme meuniers, sous le nom de \"Joseph-Antoine Santerre Inc.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions communes de SI00 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baie-des-Sables, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.11109-56) J.P.Nadeau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1956, constituant en corporation: J.-René Gauthier, Dollard Dansereau et J.-Gérard Hébert, tous trois avocats et Conseils en Loi de la Reine, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'articjes et accessoires en cuir, souliers, sacoches, ainsi que de tous objets en bois, sous le nom de \"J.P% Nadeau Ltée\", avec un capital total de S20,000, divisé en 50 actions communes de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.10132-57) J.W.Cook Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec* il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1957, constituant en corporation: Joseph William Cook, employé civil, Marc-André Blouin, courtier en assurances, tous deux de Sil-lcry, et Jean-Paul Roux, étudiant, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtier en immeubles, sous le nom de \"J.W.Cook Ltée\", avec un capital total de 810,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 378, rue du Roi, est, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le neuf \u2022 janvier 1957.y L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 p.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of December, 1956, incorporating: Mrs.Joseph-Antoine Santerre, housewife, wife of Joseph-Antoine Santerre, Joseph-Antoine Santerre, Rosaire Santerre, Jean Bearcbmans Santerre, all four of Baie-dcs-Sables, Léon Santerrer' Benoit Santerre, both of Mont-Joli, Grégoire Santerre, of Matane, and Gamier Santerre, of Rimouski, all merchants, for the following purposes: To carry on the wholesale and retail business of dealing in articles sold in departmental stores, grocer's shops, and those of grain, flour and provisions, and carry on business as millers under the name of \"Joseph-Antoine Santerre Inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of $100 each and 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Baie-des-Sablcs, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of December.1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14109-56) J.P.Nad eau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December, 1956, incorporating: J.René Gauthier, Dollard Dansereau and J.Gérard Hébert, al three advocates and Queen's Counsel, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal in leather articles and accessories, shoes, hand-bags, as well as objects in wood, under the name of \"J.P.Nadeau Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 50 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December.1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10132-57) J.W.Cook Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1957, incorporating: Joseph William Cook, civil employee, Marc-André Blouin, insurance broker, both of Sillery, and Jean-Paul Roux, student, of Quebec, for the following purposes : To carry on business as real estate broker, under the name of \"J.W.Cook Ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 378 du Roi Street, East, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General. 704 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, ê8 février 1967, Tome 89, N° 8 (P.G.10032-57) Kay Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1957, constituant en corporation: Raphaël Maurice Phillips, administrateur, Samuel J.Smiley, avocat, tous deux de Montréal, et Gertrude Gagnon Kay, ménagère et marchande, épouse séparée de biens de Alex Kay et dûment autorisée par ce dernier, de la ville de Dorval, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de métaux, sous le nom de \"Kay Industries Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.13526-56) Keystone Realties (Que.) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt décembre 1956, constituant en corporation: Murray Stem, courtier d'immeubles, Arthur Yanofsky, avocat, tous deux de St-Laurcnt et Daniel Lazare, étudiant en droit, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers d'immeubles, sous le nom de \"Keystone Realties (Que.) Ltd.\", avec un capital total de S40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera cà Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(A.G.10032-57) Kay Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1957, incorporating: Raphaël Maurice Phillips, executive, Samuel J.Smiley, advocate, both of Montreal, and Gertrude Gagnon Kay, housewife and marchande, wife separate of Alex Kay, and duly authorized by him, of the town of Dorval, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of metals, under the name of \"Kay Industries Lie\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13526-56) Keystone Realties (Que.) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1956, incorporating: Murray Stein, real estate broker, Arthur Yanofsky, advocate, both of St.Laurent, and Daniel La/are, law student, of Westmount, for the following purposes: To carry on business as real estate agents, under the name of \"Keystone Realties (Que.) Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10065-57) Kyak Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en-vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1957, constituant en corporation: Jacques de Billy, avocat et conseil en loi de la Reine, Claire Miquelon, secrétaire, fille majeure, tous deux de Québec, André Gagnon, avocat et conseil en loi de la Reine, Charlotte Risi, secrétaire,' fille majeure, tous deux de Sillery et Huguettc Morin, secrétaire, fille majeure, de Lauzon, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations afin de découvrir des mines et des minerais et lés négocier, sous le nom de \"Kyak Quebec Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.(A.G.10065-57) Kyak Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of tjie Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1957, incorporating: Jacques de Billy, advocate and Queen's Counsel, Claire Miquelon, secretary, spinster, both of Quebec, André Gagnon, advocate and Queen's Counsel, Charlotte Risi, secretary, spinster, both of Sillery, and Huguettc Morin, secretary, spinster of Lauzon, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Kyak Quebec Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 shares of $1 each.The shareholders ^of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will he at Quebec, judicial district of- Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 28rd, 1957, Vol 89, No.8 705 Date du bureau du Procureur general, le quai janvier 1957.I,'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14168-56) Landsdowne Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1957, constituant en corporation: Joseph Boretsky, Paul Boretsky, marchands, Louis Light, manufacturier et Celia Light, ménagère, épouse séparée de biens dudit Lou; - Light, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Lansdownc Corporation\", avec un capital total de 840,000, divisé en^.000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14013-56) La Plomberie Sicottc Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date (lu vingt décembre 1956, constituant en corporation: Antoine Sicotte, Roger Mcrcille, René Roy, tous trois de ville LcMoync, et Paul Sicotte, de Longueuil, tous quatre plombiers, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, plomberie, chauffage, réfrigération et exercer le commerce d'appareils s'y rapportant, sous le nom de \"La Plomberie Sicotte Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.\u2014 Le siège social de la compagnie sera à Greenfield Park, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14179-56) La Société Montmorency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un décembre 1956, constituant en corporation: Ubald Désilets, avocat, Louis Ber-nier, dentiste, tous deux de Sillery, Henri-Paul Marcotte, industriel, du Lac Bcauport, Léo-T.Julien, industriel, de Notre-Dame-des-Lauren-tides.Fernand Blouin, Jean-Charles Dion, comptables, Fernand Dion, voyageur de commerce, Jean-(harles Drolet, Paul-Henri Garneau, industriels, Joseph Fortier, gérant de banque, Rolland Parent, pédagogue, Pierre-Emile Noreau, Albert Gagnon, Paul Gingras, comptables agréés, Jean-laul Guimont, comptable agréé, m.s.s., Roger Marcotte, gérant, Armand Trottier, entrepreneur général, Jean-Paul Morneau, commerçant, Ray- \\ Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354-0 Acting Deputy Attorney Heneral.(A.G.14168-56) Landsdowne Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1957, incorporating: Joseph Boretsky, Paul Boretsky, merchants, Louis Light, manufacturer, and Celia Light, housewife, wife separate as to property of the said Louis Light, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Landsdowne Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of Januarv, 1957.P.FRENETTE, 44354-0 .Acting Deputy Attorney General.(A.G.14013-56) La Plomberie Sicottc Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1956, incorporating: Antoine Sicotte, Roger Mercille, René Roy, all three of the town of LeMoyne, and Paul Sicotte, of Longueil, all four plumbers, for the following purposes: To carry on business of general contractors in building, plumbing heating, refrigeration and deal in apparatus connected therewith, under the name of \"La Plomberie Sicotte Ltée\", with a total capital stock of 840.000, divided into 400 shares of 8100 each.\u2022 The head office of the company will be at Greenfield Park, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14179-56) La Société Montmorency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December, 1956, incorporating: Ubald Désilets, advocatd, Louis Bernier, dentist, both of Sillery, Henri Paid Marcotte, industrialist, of Lake Bcauport, Léo T.Julien, industrialist, of Notre-Damc-dcs-Laurentides, Fernand Blouin, Jean Charles Dion, accountants, Fernand Dion, commercial traveller, Jean Charles Drolet, Paul Henri Garneau, industrialists, Joseph Fortier, bank manager, Rolland Parent, pedagogue, Pierre Emile Noreau, Albert Gagnon, Paul Gingras, chartered accountants, Jean Paul Guimont, chartered accountant, m.s.s., Roger Marcotte, manager, Armand Trottier, general contractor, Jean Paul Morneau, merchant, Raymond Côté, 706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° 8 mond Côte, marchand, et Jacques Taschereau, notaire, tous seize de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"La Société Montmorency Inc.\", avec un capital total de S39.000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 7,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de S5 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1310, 1ère avenue, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14152-56) Lénor Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1956, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, avocat, Sonya Schneyer et Anne Zifkin, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises fabriquées en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre, et sous-produits, sous le nom de \"Lenor Limitée\", avec un capital total de 875,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de 810 chacune et 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.13506-56) Les Ateliers Presto Inc.Presto Motor Works Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1956, constituant en corporation: Mario Du Mesnil, avocat, Roland Savignac, notaire, tous deux de Montréal, et Jean Tellier, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens et exercer l'industrie et le commerce d'appareils et accessoires s'y rapportant, sous le nom de \"Les Ateliers Presto Inc.\u2014 Presto Motor Works Inc.\", avec un capital total de S49,000, divisé en 900 actions ordinaires de 810 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à «3842, rue Henri Julien, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14117-56) Les Entreprises de l'Iserhoff Limitée The Iserhofî Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date merchant, and Jacques Taschereau, notary, all sixteen of Quebec, for the following purposes: To carry on business as an investment and a holding company, under the name of \"La Société Montmorency Inc.\", with a total capital stock of S39.000, divided into 1,500 common shares of a par value of 81 each and 7,500 preferred shares of a par value of 85 each.The head office of the company will be at 1310, 1st Avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of December, 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14152-56) Lénor Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1956, incorporating: Cyril E.Schwisberg, advocate, Sonya Schneyer and Arme Zifkin, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To deal in merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass, and by-products, under the name of \"Lenor Limitée\", with a total capital stock of 875,000, divided into 2,500 com-mon sharse of 810 each and into 5,000 preferred of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of December, 1956.P.FRENETPE, 44354-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13506-56) Les Ateliers Presto Inc.Presto Motor Works Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1956, incorporating: Mario Du Mesnil, advocate, Roland Savignac, notary, both of Montreal, and Jean Tellier, advocate, of Westmount, for the following purposes: To carry on business as electricians and (leal in apparatus and accessories connected therewith, under the name of \"Les Ateliers Presto Inc.\u2014 Presto Motor Works Inc.\", with a total capital stock of $49,000, divided into 900 common shares of $10 each arrd 400 preferred shares of a value of $100 each.The head office of the company will he at 3842 Henri Julien Street, Montreal\", judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General» this twenty-eighth day of November 1956.P.FRENETPE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14117-56) Les Entreprises de l'Iserhoff Limitée The Iscrhbff Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day °' QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 707 du cinq Janvier 1957, constituant en corporation: Claude-R.Baillargeon, Edgar Allard, tous deux avocats, et Judith Manibal, secrétaire, fille majeure, tous de Val d'Or, pour les objets suivants: Construire, maintenir, réparer, posséder, exploiter, gérer et vendre des chemins ou des routes; faire affaires comme garagistes, sous le nom'de \"Les Entreprises de l'Iserhoff Limitée \u2014 The Iserhoff Enterprises Limited\", avec un capital total de $60,000, divisé en dOO actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val-d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le cinq, janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14038-56) Les Entreprises Triangle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1956, constituant en corporation: Bcrnadc Charctte, comptable, Annette Lcinieux, sténographe, célibataire, et Richard Dorais, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme enlrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce de matériaux de construction, de plomberie, d'électricité et de quincaillerie, sous le nom de \"Les Entreprises Triangle Inc.\", avec un capital divisé en 5,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siègi social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de.Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14177-56) Les Voyages Organisés Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1957, constituant en corporation: Jules Dupré, avocat, c.r., d'Outremont, Raymond Lotte, avocat, de la ville de Hampstcad, et Hélène Gélinas, avocat, célibataire, de Montréal, pour les objets suivants: Diriger une agence de voyage, sous le nom de 'Les Voyages Organisés Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 50 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal., Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1057.L Assistant-procureur général suppléant.44354-o p.FRENETTE.(P.G.11192-56) Lionel Bérubé Incorpore Lionel Bérubé Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première Partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ete accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provi,j(.e de Québec des lettres patentes, en date au huit janvier 1957, constituant en corporation: January 1957, incorporating: Claude R.Baillargeon, Edgar Allard, both advocates, and Judith Manibal, secretary, fille majeure, all of Val d'Or, for the following purposes: To build, maintain, repair, hold, operate, manage and sell roads or highways; carry on business as garage-keepers, under the name of \"Les Entreprises de l'Iserhoff Limitée \u2014 The Iserhoff Enterprises Limited\", with a total capital stock of $60,000, divided into 400 common shares of $100 each and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of January 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14038-56) Les Entreprises Triangle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December 1956, incorporating: Bemade Charette, accountant, Annette Lemieux, stenographer, spinster, and Richard Dorais, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors; deal in building materials, plumbing, electricity and hardware, under the name of \"Les Entreprises Triangle Lie\", with a capital stock divided into 5,000 shares without nominal or par value and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of December 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14177-56) Les Voyages Organisés Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1957, incorporating: Jules Dupré, advocate, Q.C., of Outremont, Raymond Lette, advocate, of the town of Hampstead, and Hélène Gélinas, advocate, bachelor, of Montreal, for the following purposes To direct a travel agency under the name of \"Les Voyages Organisés Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 50 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14192-50) Lionel Bérubé Incorporé Lionel Bérubé Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1957, incorporating: Edgar Allard, 708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec: 28 février 1957, Tome 89, N° 8 Edgar Allard, avocat, Judith Manibal, comptable, célibataire, majeure, et Simon Laliherté, notaire, tous trois de Val-d'Or, pour les objets suivants: Faire l'exploitation des forêts et exercer le commerce du bois et de ses sous-produits, sous le nom de \"Lionel Bérubé Incorporé \u2014 Lionel Bérubé Incorporated\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions communes de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val-d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14081-56) Mucan Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un décembre 1956, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Arono-vitch, tous deux avocats, Max Shenker, étudiant en droit et John Hamilton, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Macan Holdings Inc.\", avec un capital total dq 840,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,600 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354 P.FRENETTE.(P.G.14044-56) Magasin Continental (St-Jérôme) Ltée Continental Store (St-Jérôme) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un décembre 1956, constituant en corporation: Lorenzo Brisson, Rosario Desbiens, commerçants, et Janine Riverin, sténographe, fille majeure, tous de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de mercerie, nouveautés, tissus, produits synthétiques, quincaillerie, jouets, accessoires électriques, journaux, remèdes brevetés, article de ménage, d'épicerie, de fumeurs, de toilette, de librairie, de sport et de bibelots; faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de \"Magasin Continental (St-Jérôme) Ltée \u2014 Continental Store (St-Jérôme) Ltd.\", avec un capital total de S20.000, divisé en 2,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 427, rue Racine, est, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44354-0 P.FRENETTE.(P.G.14149-56) Marin Portraits Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a advocate, Judith Manibla, accountant, bachelor, of full age, and Simon Laliberté, notary, all three of Val-d'Or, for the following purposes: To carry on lumber operations and deal in the lumber business and in its by-products, under the name of \"Lionel Bérubé Incorporé\u2014Lionel Bérubé Incorporated\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.¦*The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitlbi.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of January, 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14081-56) Macan Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December, 1956, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, both advocates.Max Shenker, law student, and John Hamilton, secretary all of Montreal, for the following purposes : To carry on business as an investment and holding company, under the name of \".Macau Holdings Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of the par value of 810 each and into 3,600 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company will he at Montreal,'judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44354-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14044-56) Magasin Continental (St-Jérôme) Ltée Continental Store (St-Jérôme) Ltd.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of December 1956, incorporating: Lore'nao Brisson, Rosario Desbiens, merchants, and Janine Riverin, stenographer, fille majeure, all of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in small wares, novelties, fabrics, synthetic products, hardware, toys, electrical appliances, newspapers, patent medicines, household articles, groceries, smokers' supplies, toilet requisites, books, sporting goods and knick-knacks; carry on business as restaurateurs, under the name of \"Magasin Continental (St-Jennie) Ltée \u2014 Continental Store (St-Jérôme) Ltd., with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at 427 Racine street, east, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of December 1956.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14149-56) Marin Portraits Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 709 (¦[r ' i i date de l'arrêté en conseil qui l'accorde\".r Le Surintendant de l'Instruction publique, 44:îs[-(> o.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-François-'!' des division d'enregistrement de Laval.Notice is also given that from ami after February fifteenth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of Februarv 1957.P.FRENETTE, 44354 Acting Deputy Attorney General.Department of Municipal Affairs Notice is hereby given that by Order in Council No.121 under date of February 14, 1957 and pursuant to the provisions of section 43 of the cities and towns Act (R.S.Q., 1941, chapter 233), His Honour the Lieutenant-Governor in Council has approved By-law No.227 of the Municipal Council of the town of Beauport, as modified by By-law No.227-A of said Council, and enacted that, as from the date of publication of this notice, the territory mentioned in said By-law and described here-inunder is detached from the town of Villeneuve and annexed to the town of Beauport.This territory is as follows: A territory comprising a portion of lot 354 of the official cadastre of the parish of Beauport and more clearly described as follows, to wit: That part of lot 354 extending along the entire length of said lot as from the top of the cliff as far as the southerly side of Marcoux street; thence, the said part of lot 354 extending along the westerly line of said lot.as far as Boulevard-des-Chûtes, of an irregular width measured perpendicularly to said westerly line of lot 354 at the following places: 38 feet on the southerly side of Marcoux street; 38 feet on the southerly side of Avenue-du-CoIlège; 39 feet on the northerly side of Avenue-du-Collège; 44 feet on the southerly side of a proposed street at some 640 feet north of Avenue-du-Collège; 42 feet on the north side of said proposed street and finally 29 feet on the south side of Boulevard-des-Chûtes; all measurements in this official description being of English measure.PAUL DOZOIS.44370 Minister of Municipal Affairs.Department of Education No.1156-56.ERRATUM Quebec, February 17, 1957.In the notice published in the Quebec Official Gazette Of January 19, 1957, on page 251, concerning the annexation of certain lots to the school municipality of Poularies, in the county of Abi-tibi-West, the last paragraph must be changed for the following: \"this change will take effect 15 days after the date of the Order in Council by which it was granted\".O.J.DÉSAULNIERS, 44381 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the parish of St.Francois-de-Sales registration division of Laval. 730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 février 1957, Tome 89, N° 8 Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 91-20 à 91-50 et le lot 91-55 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 février 1957.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 44355-0 A VILA BÉDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Joachim-de-Chftteauguay division d'enregistrement de Chûteauguay.Avis est.par la présente donné que les lots 220-339 à 226-346.226-376.226-379,226-437,226-4 10.226-471, 226-524, 226-527 à 226-555, 226-557 à 220-610, 220-614 à 226-667, 226-670 à 226-696, 226-699 à 226-963.220-906 à 226-993.326-998.parti edes lois 226-347, 226-408, 220-409, 220-520 et deux parties des lots 220-612.220-669 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 février 1957.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 44355-0 AVILA BÉDARD.Cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de St-I.aurcnt, municipalité de la cité de St-Laurent, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné «pie les lots 87-234 à 87-247.87-258 à 87-285, 87-293 à 87-403, 87-415 à 87-417 et partie des lots 87-233 et 87-286 (rue) sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 février 1957.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 44355-0 AVILA BÉDARD.Département du Travail Notice is hereby given that part of lots 91-26 to 91-50 ami lot 91-55 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 12th, 1957.Department of I^ands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD.44355-0 Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St.Joachim-dc-Chateauguay registration division of Cliâteauguay.Notice is hereby given that, lots 226-339 to 220-346.226-376.220-379, 220-437, 226-440, 226-471, 220-524 .226-527 to 220-555, 226-557 to 220-010, 226-614 to 226-067.220-070 to 22(>-u9f>, 220-699 to 220-903.220-966 to 220-993, 226-998, part of lots 220-347.220-408.226-469, 226-526 and two parts of lots 226-012.220-009 are cancelled in virtue of article 2174A of the civil (Ode.Quebec, Febaurry the 12th.1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 44355-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St.Laurent, municipality of the city of St.Laurent, registration division of Montreal.Notice is herebv given that lots 87-231 to 87-247, 87-258 to 87-285, 87-293 to 87-403, 87-415 to 87-417 and part of lots 87-233 and 87-286 (Street) are cancelled in virtue of Article 2I74A of the civil Code.Quebec, February the 12th, 1957.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch.AVILA BÉDARD, 44355-0 Deputy-Minister.Department of Labour AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre «lu Travail, dome avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie et aux méîicrs «le la construction dans la ré-gion de Rimouski, rendue obligatoire par le décret numéro 802 du 8 juillet 1953, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouvem.eur en Conseil la modification suivante au«lit décret, dans sa teneur modifiée: L'alinéa intitulé \"Zone II\" apparaissant à l'article III sera remplacé par le suivant: \"Zone II: Les villes de Mont-Joli et de Matane ainsi que la municipalité de Price, comté «le Matane.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette offi- NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 103 ami amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry and trades in the region of Rimouski, rendered obligatory by the decree No.802 of July 8, 1953, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the said decree, as amended : The paragraph entitled \"Zone II\", in section III, will be replaced by the following: \"Zone II: The towns of Mont-Joli and Matane and the municipality of Price, county of Matane.\" The publication of the present notice docs not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Queoeê Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 731 cielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail Gazette, the Honourable Minister of Labour will recevra les objections que les intéressés pourront consider the objections which the interested désirer formuler.parties may wish to set forth.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Miilist ère du Travail, Department of Labour, Québec, le 23 février 1957.443S9-o Quebec, February 23, 1957.44389-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1911.chapitre 163 et amendements), que la Commission conjointe de l'Industrie de la robe de la province de Québec lui a présenté une requête à l'effet d'apporter les modifications suivantes au décret numéro 3519 du 24 septembre 1940, dans sa teneur modifiée, relatif à l'industrie de la robe dans la province de Québec.1° L'alinéa \"a\" du paragraphe \"A\" de l'article I sera remplacé par le suivant: ''«) Vêtements féminins tricotés, faits de tissus tricotés, pourvu : 1° Que les tissus et les vêtements au complet soient faits par le même employeur; 2° Que tel employeur se serve régulièrement d'au inoins une machine à tricoter à chaîne (warp) ou deux machines circulaires à tricoter \"jersey\" ou trois machines à tricoter à plateau (Hat bed), ou autres machines du même genre.\" 2° L'article III, \"Définition des métiers\" sera abrogé et remplacé par le nouvel article III suivant: \"III.Définition des métiers: Opérateurs: Ceux qui, à l'aide de machines à coudre et selon les règles de l'art, assemblent tout article visé par le présent décret, une fois taillé; ce terme comprend aussi les opérateurs de section (section operators) qui sont capables d'exécuter à l'aide de machines à coudre et selon les règles de l'art, une ou plusieurs des opérations lesquelles, réunies, comprennent toute la couture de l'un quelconque des vêtements assujettis au décret.Ce terme ne comprend pas, cependant, les ouvriers préposés au fonctionnement des machines suivantes, savoii : les machines à boutonnières, les machines à froncer, les machines à plisser et piquer, les machines pour faire et rabattre les bas de robes, et les machines à boutons-pression, et qui sont appelé \"cpératturs de machines spéciales\".l'r< curs: Ceux qui font le pressage de tout article compris dans la juridiction du présent décrel une fois cousu par un opérateur.Asmsjants-presseurs: Ceux qui font le pressage accessoire et le pressage des pièces afin de préparer ces articles pour l'opérateur.Examinateurs: Ceux qui font l'inspection du vêtement une fois terminé pour découvrir les défauts de style ou de façon, et qui ont l'expérience voulue pour trouver ces défauts.Ouvriers généraux: Ceux qui font les divers ouvrages de fabrication accessoire à celle des vêtements comme, par exemple, le coupage des n's et le nettoyage; ces diverses opérations ne sont cependant pas limitatives.Finisseurs: Ceux qui font, selon les règles fle 1 art, la couture à la main de tout morceau 0,1 garniture et tout autre ouvrage nécessaire Pour terminer la fabrication du vêtement, une NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941.chapter 163 and amendments), that The Joint Commission for the Dress Industry of the Province of Quebec, has submitted to him a petition to amend the decree No.3519 of September 24, 1940, as amended, relating to the Dress Industry in the Province of Quebec foi 8 cousu par l'opérateur, y compris, entre utres, le posage à la main des boutons-pression, 1.Paragraph a) of subsection \"A\", section I, will be replaced by the following: \"a) Knitted garments for females, made of knitted fabrics, on condition: 1) That the fabrics and the fully completed garments are made by the same employer: 2) That such employer regularly operates at least one (1) warp knitting (tricot) machine, or two (2) jersey knitting (circular) machines, or three (3) flat bed knitting machines; or knitting machines of similar types.\" 2.Section III, \"Definition of Crafts.\" will be repealed and replaced with the following new section III: \"III.Difmition of crafts: Operators: Those actually preforming by ordinary sewing machine in a workmanlike manner the operation of sewing together any of the products falling within the present, jurisdiction, after the said garment has been cut; as well as those who, being (section operators), are able to and actually perform by sewing machine in a workmanlike manner, any one or more of the operations which together comprise the complete work of sewing any one of the garments falling within the jurisdiction of the present decree, but excepting such workers who operate the following machines, namely: button-hole, tucking, shirring, bottom-making or felling and/or snap-fastening machines, and who are called \"special machine operators\".Pressers: Those actually performing the work of pressing any or all the products falling within the juris b'ction of the present decree after the garment has been sewn together by the operator.Assistant pressers: Those actually performing the work of incidental pressing and piece pressing necessary so as to make the above-mentioned articles ready for the operator.Examiners: Those actually performing the work of inspecting a finished garment, for fautls in workmanship and/or styles, and having a complete knowledge of the requirements of the garment.General hands: Those actually performing Sundry Factory work incidental to the manufacture of a garment as, for example, but not so as to limit the generality of the foregoing, thread cli-ping and cleaning.Finishers: Those actually performing in a workmanlike manner the operation of sewing by hand any details, trimmings, or other necessary work for the completion of the garment after it has been sewn by the operator, and, without limiting the generality of the foregoing, including 732 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 février 1957, Tome 89, N° 8 des boutons, des cravates, des ceintures, des boucles et des oeillets ainsi que le rabattage des bas.Drapeurs: Ceux qui font le travail de d Tapement lequel précède et prépare celui des finisseurs.Plieurs: Ceux qui font le pliage d'un vêtement terminé pour fins d'empaquetage, mais qui n'exécutent aucun travail de pressage.ÉtaJeurs: Ceux qui étendent le drap employé-dans la fabrication des vêtements en vue de préparer le travail du coupeur.Opérateurs de machina spéciales, classe \"A\": Ceux qui exécutent les opérations qui consistent à froncer, plisser, à faire les boutonnières cl les a jours.Opérateurs de machines spéciales, classe \"B\": Ceux qui exécutent les opérations qui consistent à dentaler, à faire les bas, à poser les boutons-pressions, à rabattre et à couper les bas.Définition des coupeurs par classes Classe I.Coupeurs compétents: Ceux qui échelonnent les grandeurs et placent ou reproduisent les patrons sur les tissus ou sur le papier, qui étendent ou étirent les tissus, taillent aux ciseaux, à la machine, au couteau ou autrement, suivant les règles de l'art, tous les tissus bruts employés dans la fabrication des vêtements visés par le présent décret.Classe II.Coupeurs semi-compétents: Ceux qui font une partie mais pas tout le travail des coupeurs compétents; ils n'échelonnent pas les grandeurs ou ne placent ni reproduisent les patrons sur les tissus ou sur le papier, sauf dans le cas des garnitures (trimmings).Un coupeur semi-compétent peut s'adresser au Comité paritaire pour obtenir la permission de faire le travail d'un coupeur compétent en vue d'une promotion.Cet employé, obtenant pareille permission d'effectuer le travail de la classe voisine plus élevée, ne peut réclamer par poursuite un salaire plus élevé que celui qu'il recevait en vertu de son dernier permis.\" 3° L'article VI sera remplacé par le nouvel article suivant: \"VI.Heures de travail: a) Heures régulières de travail: La semaine régulière de travail est de quarante (40) heures réparties en cinq (5) jours de huit (8) heures chacun, du lundi au vendredi inclusivement de chaque semaine.Les heures de chaque jour sont réparties entre 8.00 a.m.et 5.00 p.m.avec un intervalle d'une heure pour le repas du midi, de midi à 1.00 p.m.Tout travail exécuté en dehors de ces heures est considéré comme travail supplémentaire.6) Travail supplémentaire: Un maximum de huit (8) heures de travail supplémentaire est permis chaque semaine pendant les quatre (4) premiers jours en autant (pie ce travail supplémentaire n'excède pas deux (2) heures par jour.Salaire et demi: Tout travail exécuté entre 5.00 p.m.et 0.00 p.m.en plus de quarante (40) heures doit être rémunéré au taux de salaire et demi.Le temps perdu par un salarié pour cause de maladie, de suspension ou de manque de travail ou à la suite .des fêtes statutaires ou religieuses doit être ajouté aux heures de travail afin d'établir la semaine de quarante (40) heures, mais ce calcul ne doit affecter que le travail supplémentaire exécuté entre 5.00 p.m.et 0.00 p.m.Nonobstant tonte autre disposition à ce contraire, tout travail supplémentaire exécuté après 6.00 p.m.doit être rémunéré à raison de salaire such work by hand as sewing on the snaps, hut-tons, ties, belts, loops, hooks and felling bottoms Drapers: Those actually performing the work of draping in preparation for the work of finisl s, Folders: Those actually performing the work of fol ling a finished garment for the purposi of packing, but not performing any of the work of pressing.Spreaders: Those actually performing the work of appreading the cloth used in the manufacture of garments in preparation for the work of the cutter.Special machine operators class \"A\": Those wdio perform the following operations: Tucking, shirring, button-hole making and hemstitching.Special machine operators class \"B\": Those who perform the following operations: Pinking, bottom-making, snap fastening, bottom-felling, bottom-cutting.Definition of grades Grade I: Skilled cutters: Those who actually grade sizes and make markers on material- or on paper, lay up or spread materials, cut with shears, machine, knife or otherwise, in a workmanlike manner, all raw material used in the manufacture of garments falling within the scope of the present decree.Grade II: Semi-skilled cutters: Those who actually do some but not all the work of fully-skilled cutters and who do not make markers or grade sizes either on material or on paper except on (trimmings).A semi-skilled cutter may apply to the Joint Committee to permit him to perform the work of a skilled cutter in order to enable him to advance into the next higher grade.No employee so permitted to perform the work of the next higher grade shall be entitled to sue for higher wages than those he received at the time of the last permit.\" 3.Section VI will be replaced with the following new Section VI: \"VI.Working hours: a) Regular hours: A week's work shall consist of 40 hours divided into five working days of 8 hours each, irom Monday to Friday, inclusive, of each week.Each working day shall begin at 8.00 .m.and shall continue until 5.00 p.m.with an interval of one hour for lunch, from 12.00 o'clock noon until 1.00 p.m.All work outside of the aforesaid hours hall be considered as overt ime.b) Overtime: A total not exceeding eight ! >urs of overtime shall be permitted in each v eek during the first four working days thereof, provided that such overtime shall be limited to two hours in any one working dav.Time and one-half overtime: All overtime worked between 5.00 p.m.to 6.00 p.m.in excess of 40 hours shall be paid for at the rate of time and one-half.All time lost by an employee because of incapacity due to sickness or lay-off or slack periods, or resulting from any leg il or religious holiday, shall be added to time worked in order to compute the (40) hour work week, but shall affect only the overtime worked between a.OO p.m.to 6.00 p.m.Notwithstanding any provision herein to the contrary, all overtime work performed after 6.00 p.m.shall be, paid for at the rate of time QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1057, Vol.SO, No.8 733 ct demi excepté dans les circonstances prévues au paragraphe \"c\" ci-dessous.c) Aucun travail ne doit être exécuté les samedi et dimanche.Aucun travail ne doit être exécuté avant 8.00 a.m.et après 7.00 p.m.les mardi, mercredi, jeudi cl avant S.00 a.m.de même qu'après 5.00 p.m.le vendredi de chaque semaine de travail.d) Aucun travail ne peut non plus être exécuté pendant l'interruption d'une heure pour le repas du midi, soit entre midi et 1.00 p.m.chaque jour ouvrable.r) Le salarié ne peut refuser d'exécuter le travail supplémentaire ci-haut décrit lorsqu'il est requis de le faire.Durant la période du 1er avril au 15 juin, les employeurs ont le droit de déduire de la période de travail supplémentaire des ouvriers travaillant à la pièce, tout le temps pcnlu par ces ouvriers à la suite de retards ou d'absences volontaires./) Nonobstant les dispositions du présent article, il s'applique à tous les employeurs ct salariés, y compris les travailleurs à domicile, assujettis au présent décret.\" \u20221° L'article VIII sera abrogé et remplacé par le nouvel article suivant: \"VIII.Salaires minima pour le travail à Vheure ou à la pièce: Les taux horaires minima suivants lesquels comprennent le boni de vie chère, s'appliquent aux salariés énumérés ci- après: Métiers: l'heure Operateur.§ 0.715 Faiseur d'échantillon.0.745 Drapeur.0.095 Finisseur.0.6425 Examinateur.0.6125 piîcur.rrrr.0.5825 Ouv 1 ier général.0.5825 Près leur (sexe masculin).1.18 Presse use.0.82 As iant-presseur.0.6425 Coupeur compétent, classe 1.1.32 Coupeur semi-compétent, classe II.1.07 Étaleur.0.78 Opérateur de machines spéciales, classe \"A\".0.6425 Opérateur de machines spéciales, classe \"M\".0.5825 Aucun taux à h pièce ne peut être fixé de faç.-i à rapporter nv ins que les minima ci-haut.\" 5° L'article IX-A sera abrogé et remplacé par !«\u2022 nouvel article suivant: \"i X-A.Dont de vie chère: Tout salarié assujetti au présent décret, qu'il travaille sur une base horaire ou à la pièce, doit recevoir un boni de vie chère en plus de son salaire régulier de la façon ci-après décrétée: «) Tout coupeur (Classe I et classe II) et ton! prt'SSeur, à l'exception de l'assistant-presseur, doit recevoir un boni de vie chère «le vingt-trois cents .'t demi ($0.23>(>) l'heure.Toute pres-seus à l'exception de l'aîde-presseuse doit roc, \\ j|- |ln |)OMj (|t.vje chere de vingt cents et demi (S9.2OJ0 l'heure.b) Tous les autres salaries, y compris les aPP'' '.'is doivent recevoir un boni de vie chère «dix-huit cents et demi ($9.18^) l'heure., c) lout travailleur à domicile doit recevoir a titre de boni de vie chère, une somme a Hi-, «onnelle selon les dispositions de l'article XII du présent décret.st of living obnus of twsnty-three cents (23^ per hour.All female pressera excluding assist mt nressers, shall be nai 1 a cist of living bonus of twenty an I one-half cents (21J^-) per hour.b) All other employées, incluiing,apprentices, shall be pair! a cost of living bonus of eighteen an I one-half cents HSU-) per hour.c) Every homeworker shall be pai I, as a cost of living bonus, an a I litional sum as provided under section XII.of the pre«sent decree.(7) Every enrdoyer m is!, on orb.-'or:* t'r- tenth of each mmth, forwar 1 to an 1 file at the office of 734 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° 8 Commission conjointe de l'industrie de la robe de la province de Québec, un rapport couvrant le mois précédent, indiquant séparément les paiements desdits bonis de vie obère faits à chaque salarié régi par le présent décret et ce, pour la période de paye et de la manière prescrite par la Commissions conjointe et sur les formules que pourra fournir ladite Commission conjointe.e) Les augmentations du boni de vie chère entrent en vigueur le premier avril 1957 et, d'ici là, l'ancien boni de vie chère doit être payé./) Tout employeur qui a accordé une augmentation à ses salariés entre le premier janvier et.le premier avril 1957, en vertu d'une convention collective de travail intervenue entre toute partie eo-contractante s'est de ce fait conformé aux dispositions du présent article jusqu'à concurrence du montant de l'augmentation versée.g) A compter du premier mai 1957, tout, employeur assujetti au présent, décret est tenu d'incorporer le boni de vie chère dans le taux de salaire payable à chaque salarié rémunéré sur une base de temps (time work).A compter du premier mai 1957.les dispositions du paragraphe ne s'appliqueront qu'aux travailleurs à la pièce.\" 0° L'article X sera abrogé et remplacé par le nouvel article suivant: \"X.Apprentis: Les employeurs ayant sept coupeurs compétents et semi-compétents ou plus ont le droit d'employer un apprenti.Les ateliers employant moins de sept coupeurs compétents et semi-compétents n'ont pas le droit d'employer d'apprenti.Un apprenti-coupeur est^celui qui apprend le métier et les apprentis-coupeurs qui travaillent pour la première fois dans l'industrie après la mise en vigueur du présent dé*cret, doivent travailler selon l'échelle de salaire suivante, lesquels salaires comprennent le boni de vie chère: Apprentis-coupeurs: Theure Premier t rimestre.80.74 Deuxième trimestre.0.795 Troisième trimest re.0.85 Quatrième trimestre.0.905 Cinquième trimestre.0.90 Sixième trimestre.1.015 Subséqucmment, le salaire est le même que celui des coupeurs semi-compétents.Le nombre des apprentis des autres métiers dans tout atelier ne doit pas excéder quinze pour cent.(15%) du nombre des salariés d'un tel atelier.Un appenti-opérateur, finisseur, presseur, presseuse, assistant presseur, examinateur, ouvrier général, opérateur de machines spéciales et plieur est un commerçant et doit être payé d'après l'échelle suivante, le boni de vie chère y étant compris: Apprenti presseur: Theure Premier trimestre.S0.74 Deuxième trimestre.0.795 Troisième trimestre.0.85 Quatrième trimestre.0.905 Cinquième trimestre.0.96 Sixième trimestre.1.015 Septième trimestre.1.07 Huitième trimestre.1.125 Et, subséqucmment, suivant le taux établi pour son métier.Apprentie presseuse: Theure Premier trimestre.0.50 Deuxième trimestre.0.55 Troisième trimestre.0.60 Quatrième trimestre.0.05 Cinquième trimestre.0.70 Sixième trimestre.0.75 the Joint Commission for the Dress Industry of the Province of Quebec, a report for the preceding month showing separately the payments ol the aforementioned cost of living bonuses made to each employee governed by the present Decree, for the pay period, in the manner and on such forms as may be prescribed or furnished by the said Joint Commission.e) The increases contained in the aforementioned cost of living bonuses shall come into effect on April 1st, 1957.until which said date the former cost, of living bonuses shall apply./) Any employer who has paid an increase to his employees between January 1st and April 1st, 1957, in virtue of a collective lahour agreement existing between any of the co-contracting par-tics hereto, shall be deemed to have complied with this section to the extent of the act ual amount of increase paid.g) As and from May 1st.1957, every employer governed by the present Decree shall be obliged to incorporate the, cost of living bonus into the rate of wages payable to each employee employed on a time work basis.After May 1st.1957, sub-section () Si le salarié n'a pas terminé une année de s( rvices continus à l'emploi de son employeur, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum d'autant de 5-12 de journées de travail qu'il a de mois de calendrier de services continus pour son employeur.Apprentice finisher: per hour 1st three months.SO.50 2nd three months.0.5225 3rd three months.0.545 4th three months.0.5675 5th three months.0.59 6th three months.0.6125 Apprentice operator: per hour 1 st three months.0.50 2nd three months.0.54 3rd three months.0.58 4th three months.0.62 5th three months.'.0.06 6th three months.0.70 Apprentice examiner: per hour 1 st three months.0.50 2nd three months.0.5175 3rd three months.0.535 4th three months.0.5525 5th three months.0.57 6th three months.0.5875 And thereafter in accordance with the rate in their respective craft.Apprentice general hand: per hour 1st three months.0.50 2nd three months.0.515 3rd three months.0.53 41 h three months.0.545 5th three months.0.56 Apprentice folder: per hour 1st three months.0.50 2nd three months.0.515 3rd three months.0.53 4th three months.0.545 5th three months.0.56 And thereafter in accordance with the rate in their respective carft.Apprentice assistant presser: per hour 1st three months.SO.50 2nd three months.\".0.535 3rd three months.0.57 4th three months.0.605 And thereafter in accordance with the rate in their respective craft.Special machine operator (A) : per hour 1st three months.0.50 2nd three months.0.5225 3rd three months.0.545 4th three months.0.5675 5th three months.0.59 6th three months.0.0125 Special machine operator (B): per hour 1st three months.0.50 2nd three months.0.515 3rd three months.0.53 4th three months.0.545 5th three months.0.56 And thereafter in accordance with the rate in their respective craft.\" 7.Section X-A will be amended as follows: i.Paragraph 1 will be deleted and replaced with the following: \"1.With the exception of homeworkers for whom special provision is made under Section XII of this decree, each and every employee, governed by the present decree, is entitled: o) After one year's continuous service in the employ of his employer, to a continuous annual vacation with pay for a minimum duration of 7 days, comprising at least 5 working days.b) If the employee has not yet completed a year's continuous service in the employ of his employer, to a continuous animal vacation with pay, having a minimum duration of as many 5-12's of working days as the number of calendar months during which he has been continuously in the employ of his employer. 730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 février 1957, Tome 89, N° 8 c) Si, pour quelque raison que ce soit, l'emploi d'un salarié est terminé avant qu'une année de services continus ne soit complétée, ou si cet emploi est commencé et terminé pendant une année de services continus, ce salarié, au terme de l'emploi, a droit à une indemnité pour congé équivalente à 2% du salaire qu'il a gagné quand il était à l'emploi de l'employeur pendant cette année de services continus.\" ii.L'alinéa 2 sera abrogé et remplacé par le suivant: \"2° La période annuelle de services continus à l'emploi d'un employeur qui donne droit «\\ chaque congé annuel payé commence le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.La première année de services continus commence le 1er juin 1950.\" 8° i.L'article XII sera modifié en ajoutant ce qui suit après l'alinéa \"4-a\": \"De plus, tout travailleur à domicile doit recevoir une somme équivalente à 34% de ses recettes, comprenant: a) Le boni de vie chère.30% 6) Vacances annuelles payées.2% c) Jours de fêtes payés.2% ii.L'article XII sera de plus modifié en insérant l'alinéa suivant après l'alinéa \"4-6\": \"4-bb) La Commission Conjointe a le droit de fixer et de déterminer définitivement les taux payés dans les ateliers semblables de ladite industrie pour des opérations de même nature, ou dans un atelier confectionnant des vêtements semblables, ou dans un atelier ayant mis en vigueur un système de répartition du travail (section work system).\" 9° L'article XV-A sera abrogé et remplacé par le suivant: \"XV-A.10 A l'exception des travailleurs à domicile, lesquels sont sujets aux dispositions de l'article XII du décret, tous les salariés régis par ledit décret ont droit aux cinq (5) jours de fêtes suivantes payés chaque année, peu importe la journée de la semaine où ils tombent, que ce soit un jour de travail ou non, savoir: i.Le Premier de l'An; ii.Le Vendredi-Saint; iii.La Confédération; iv.La Fête du.Travail; v.Le Jour de Noël; pourvu qu'ils aient travaillé au moins un an dans l'industrie et deux (2) mois pour le même employeur avant la date de la fête statuaire, le tout sujet aux conditions et règles suivantes: a) Tout salarié absent une journée complète la semaine de travail dans laquelle tombe un des \"jours de fête ci-haut mentionnés n'a droit qu'à 80% de la rémunération accordée pour ce jour de fête.b) Tout salarié absent deux journées complètes la semaine de travail dans laquelle tombe un des jours de fête ci-haut mentionnés n'a droit qu'à 50% de la rémunération accordée pour ce jour de fête.c) Tout salarié absent plus de deux journées la semaine de travail dans laquelle tombe un jour de fête n'a droit à aucune rémunération pour ce jour de fête.Toutefois, toute perte de temps causée par la maladie d'Un salarié, une suspension par l'employeur (layoff), un jour de fête statuaire ou religieuse ne doit pas être considérée comme absence pour les fins du présent article.c) If for any reason whatsoever, empl lyment of an employee is terminated before a year of continuous service is complete I, or is connu tnce I and terminate 1 during a year of continuous scr-vice, thesa>demployee shall, at the time I' ¦ em-ployment is so terminate I, be iniemnificl, in lieu of vacation with pay, with a sum eq lal to 2% of the wages earned by him in (Vil p ulion of the sai I year of continuous service during which he was in the employ of the empl >ver,\" ii.Paragraph 2 will be delete 1 and is replaced with the following: \"2.For each annual vacation with pay, Ihe period of a year's continuous service in the employ of any empl >ycr which gives right to such vacation begins on the 1st day of June of one year and ends on the 31st dav of May of the fol-lowing year.The first year of c intimions service shall be deeme I to begin on June 1st, 1956.\" 8.i.Section XII wall be amen le I by a ! ling after paragraph 4-a) the following: \"In addition to the foregoing, each homeworkcr shall be entitled to receive and shall be paid a sum equivalent to 31% of such employe/'-, earnings, which includes the following: a) Cost of living bonus.30% b) Annual vacation with pay.2% c) Holidays with pay.2% ii.Section XII will be further amended by adding after paragraph 4-/;) the following: \"4-bb) The Joint Commiision shall have the right to fix and finally determine the rates paid in comparable shops in the Industry for similar operations, or in a shop manufacturing comparable garments, or in a shop operating under a section work system\".9.Section XV-A will be deleted and is replaced with the following: \"XV-A.1.With the exception of homeworkers for whom special provision is made in Section XII of the present decree, each and every employee governed by the present decree, shall he granted the following five holidays with pay each year, irrespective on which day of the week they may fall, and whether or not such days fall on a woork day, to wit: i.New Year's Day; ii.Good Friday; iii.Confederation Day; iv.Labour Day; v.Christmas Day; provided that the said employee has been employed at least one year in the industry and two (2) months for the same employer prior to the date of a legal holiday, the whole subject to the following rules and conditions: a) Any employee who is absent for any one full day during the work week in which any of the aforesaid holidays fall, shall be entitle;! to receive only 80% of the pay granted for .such holiday; 6) Any employee wdio is absent for two full days during the work week in which any f the said holidays fall, shall be entitled to receive only 50% of the pay granted for the said holiday.c) Any employee who is absent for more than two days during the work week in which a legal holiday falls, shall not receive any pay for the said holiday.However, the loss of time caused by the sickness of the employee or (layoff) from work by the employer, or resulting'fromany legal or religious holiday, shall not be deemed to be absences within the meaning of this section. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 737 2° Pour ces fêtes, le salarié doit recevoir: a) Le salaire qu'il aurait gagné durant la journée, s'il est payé exclusivement sur une hase de temps; b) Une journée complète de salaire calculée d'après le taux minimum prévu pour le métier ou IVccunation de tel salarié dans le présent décret, s'il est rémunéré à la pièce.\" 10° L'article XVI-A sera modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: '\u2022Tous les travailleurs à domicile doivent s'enregistrer comme tels à la Commission conjointe et lui fournir tous les renseignements qu'elle peut iliniuni'er.Chaque travailleur à domicile est tenu «le faire cet enref istrement au bureau de la Commission conjointe dans les trois (3) jours qui suivent la date de son emploi à ce titre.\" Lfl publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sent contenues.Seul- un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vi« ueur à la date de sapul licath n dans la Gazette officielle de Québec.Dura11 1 is trente jours à compter f'e la date de pu .lication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-Minirtre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 23 février 1957.44389-o AVIS L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendement 0.que les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à l'effel de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La < hambre de Construction Inc.de Montréal; Et.d'autre part: \"The Building and Construction Trades Council of Montreal and Vicinity\"; \"Le Conseil des Syndicats des Métiers de la Construction de Montréal\", pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions ci-après il écrites: CHAPITRE PREMIER Règlements généraux TITRE PREMIER juridiction section 1 \u2014juridiction territoriale Article 1.La juridiction territoriale de la convention comprend: Q) L'Ile de Montréal et un rayon de quinze Uo) nulles de ses limites, à l'exception des districts électoraux de Verchères, Saint-Jean, d'Iberville, 'Assomption et Terrebonne et des villes de Cham-b,y et Port Chambly; 2.For the said holidays, the employee shall receive: a) The wages the said emoloyee would have earned during the said day if he is exclusively paid on a time basis; b) One full day's pay calculated on the minimum rates provi led for t'ie said employee's craft in the present decree, if the said employee is employed on a piece-work basis.\" 10.Section XVI-A will be amended by adding thereto the following paragraph: \"All homeworkers shall re^iVer as such with the Joint Commissi m and s'ijII furnish it with such information as it may r quire.Such registration must be filed by cuh homewcrker in the office of the Joint Commi sion no liter than three days following the date of cmpIoyrh:nt of each homeworker.\" The publicati-n of the present notice does not render obligatory the provisions cent incd therein.Such provisions, with or w't':o it amendments, can onlv be rendered obligatory by an Order in Council which crmes into force o \u2022 the date of its publication in the Que'.ec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Q-eb-c Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to s^t forth.G Ê HARD TERM BLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 23, 1957.44389-o NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties hereafter mentioned have submitted to him a request to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: The Builders Exchange Inc., of Montreal, And, one the other part: The Building and Construction Trades Council of Montreal and Vicinity; \"Le Conseil des Syndicats des Métiers de la Construction de Montréal\", for the employers ami the employees of the industry and the trades concerned, according to the following conditions: FIRST CHAPTER General regulations » FIRST TITLE jurisdiction section 1.\u2014 territorial jurisdiction Article 1: The territorial jurisdiction of this Agreement comprises: a) The Island of Montreal and a radius of fifteen (15) miles from its limits with the exception of the electoral districts of Verchères, St.John, Iberville, L'Assomption and Terrebonne and the towns of Chambly and Fort Chambly. 738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S3 février 1957, Tome 89, N° 8 b) La cité de Snlnberry-de-ValIcyfield et la municipalité d'Ormstown.section 2 \u2014 juridiction professionnelle Article 2.Cette convention s'applique à tous les travaux de construction, de génie et de bâtiment et à toutes réparations et démolitions, y compris l'installation d'ascenseurs et la construction de générateurs, de bouilloires et de réservoirs.Il régit tout travail exécuté sur les lieux de tout contrat, qu'il soit fait dans un enclos séparé pour cette fin ou non ou dans un bâtiment subissant des réparations, rénovations ou additions.Articles.\u2014 Exemptions: Cette convention ne s'applique cependant pas: a) au travail de production exécuté dans les boutiques, ateliers mécanisés et fabriques; b) aux salariés permanents, tel que définis par la Loi de la convention collective, excepté lorsqu'ils exécutent du travail de construction nouvelle; c) aux travaux de construction exécutés dans les cimetières; d) aux opérations de camionnage visées par le décret numéro 913 du 10 juin 1948 et ses amendements; e) aux travaux de voirie exécutés pour le compte de l'un ou l'autre des départements du Gouvernement provincial, déjà assujettis en fait à la Cédule des Justes Salaires, en exécution de l'arrêté ministériel numéro 800 du 21 avril 1929 et ses amendements; /) à l'industrie minière pour ce qui est des travaux exécutés aux puits «le mine; g) à l'exploitation forestière ainsi qu'à l'opération des moulins à scies, à pulpe et.à papier; h) aux travaux d'installation et de réparation d'ameublement mobile de bureau, s'ils sont exécutés par les salariés permanents du propriétaire ou du locataire d'un immeuble.i) aux cités et villes et aux corporations municipales pour ce qui est des travaux de réparation et d'entretien de leurs propres immeubles, ou pour ce qui est des travaux de construction, de réfection ou d'entretien d egout, de pavage, de trottoirs et autres travaux du même genre exécutés sous leur contrôle immédiat; (mais cette exemption ne s'étend pas aux entrepreneurs et aux sous-entrepreneurs qui exécutent les mêmes travaux en régie ou à forfait pour le compte desdites cités, villes ou corporations municipales) ; j) aux compagnies de chemin de fer en ce qui concerne les travaux ordinairement exécutés par les préposés à l'entretien qui sont déjà régis par une convention collective avec lesdites compagnies.TITRE DEUXIÈME taux de salaires b) The city of Salaberry-dc-Valleyficld and the municipality of Ormstown.Section 2.\u2014 professional jurisdiction Article 2: This Agreement shall apply to all construction and all engineering construction and building operations, demolition and repairs, including the installation of elevators and the construction of steam generators, boilers and tanks.It shall govern all operations on the site of any contract whether done in an enclosure set .-mart thereon or not.or in any edifice undergoing repairs, renovations or additions* Article 3: Exemptions: This Agreement, shall not, however, apply to: a) Production work done in shops, plants and factories; b) Permanent employees as defined by the Collective Agreement Act except when doing new construction work; c) Building operations performed in cemeteries; d) Trucking operations governed by decree No.913 of Kith June, 1948.and its amendments; c) Road operations earricd out for the account of any department of the Provincial Government which are already subject to the Fair Wage Schedule under Order-in-Cohncil No.S')0, of the 24th April, 1929, as amended; f) The mining industry as regards work done in mine shafts; g) Togging operations and the operation of pulp, paper and saw mills; h) Installation and repair operations carried out in connection with moveable office furniture when done by permanent employees of the owner or tenant of a buil ling; ?) Cities, towns and municipal corporations in respect to repair or maintenance work on their own buil lings, or to construction, rebuil ling or maintenance work on aque lucts, sewers, pavings, sidewalks and other similar operations performed under their immediate control; (but this exemption docs not extend to contractors or sub-contractors carrying out the sun\" operations under the control of, or by contract for the said cities, towns or municipal corporations) ; j) Railroad companies in respect to operations ordinarily performed by maintenance men of the systems who are already covere Ibv a collective agreement with the said companies.SECOND TITLE wage rates section 3 \u2014taux minima de salaires section 3.\u2014 general schedule of wage rates Article 4: Les taux minima de salaires suivants Article 4: The following minimum wage rates doivent être payés: shall he payable: partie a Mette Taux horaires à partir du 1er avril 1er avril 1957 1958 Briquetcur.$2.20 $2.30 Poseur de blocs de ciment____ 2.20 2.30 Calfat.1.55 1.65 Finisseur de ciment.1.80 1.90 Charpentier, menuisier et mécanicien.$2.00 $2.10 part a Ilourhf Rites Starting 1st April W April Trades 1957 1958 Bricklaver.$2.20 $2.30 Cement block layer.2.20 2.30 Caulker.1.55 1.&» Cement finisher.1.80 1-90 Carpenter, joiner and mill- Rigger.1.65 1.75 Sheet metal worker, roofer.2,00 2.10 Helper to above.1.60 1.70 Sheet metal welder.'.2.00 2.10 Steeplejack.2.00 2.10 Steam and hot water generation mechanic (horizontal heating surface, twenty (20) ft.).1.80 1.90 Helper to above.1.55 1.05 Teamdriver, carter.1.40 1.50 Trucker, (cartage and hauling) general.1.40 1.50 part b Material checker ami timekeeper.$59.00 $63.00 Yardman.58.00 62.00 Night Watchman.53.00 57 00 Night Watchman \u2014 employed also as fireman, work requiring fourth-class certificate.64.00 68.00 SECTION 4 \u2014 DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT.LES TAl'X MINIMA DE SALAIRES Article 5: Les salariés de toute catégorie temporairement affectés par le même employeur à une occupation autre que celle de leur métier doivent continuer de recevoir les taux de salaire de leur propre métier, peu importe le nombre d'heures consacrées^ chaque jour, à telle autre occupation.Ceci ne s'applique pas aux salariés exclusivement affectés à un autre travail que celui de leur métier.Article 6 Dans tous les métiers où un matériel autre que le produit régulier et reconnu est utilisé, comme par exemple, une brique en -verre au lieu d'une brique en terre glaise ou en argile, le taux du salaire du métier approprié doit s'appliquer.Article 7.Les métiers de charpentier, menuisier et mécanicien comprennent les opérations suivantes: a) formes à béton (boutique ou chantier), po-sage de moustiquaires, (bois ou métal), chassis, fenêtres et cadres (bois ou métal), \"weatherstrips\" bardeaux, revêtements de murs, bois ou composition, divisions en acier et «l'ameublement, tels que comptoirs et tablettes (fixes ou mobiles).Article 8.Le travail préparatoire doit être accompli par des peintres et des décorateurs sujet au taux minima de salaire établis pour ces nu-tiers.Dans les édifices industriels, toutefois, un tel travail peut être accompli par des journaliers non qualifiés.Article 9.Les métiers de couvreur et de travailleur de métal en feuille comprennent toute section 4.\u2014 special provisions on wa(ie rates Article 5: All categories of employees temporarily employed by the same employer at other than their trade work, shall continue to be paid the wage rate of their own trade irrespective of the number of hours devoted per day to such other work.This does not apply to employees engaged exclusively at work other than their trade.Article 6: In all trades where any other material is erected in place of the regular and recognized commodity, for example, a glass brick for a brick of clay or shale, the appropriate trade wage rate per hour shall apply.Article 7: The trades of carpenter, joiner and millwright shall include the following operations: a) concrete forms (yard or job), the erection of screens (wood or metal), sashes, windows and frames (wood or metal), weatherstrips and shingles, siding, wood or composition, steel partitions and equipment, such as counters and shelving, moveable or immoveable.Article 8: Preparatory work shall be done by painters and decorators and shall be subject to the minimum wage rate in such trades.In industrial buildings, however, such work may be done by common labourers.Article 9: The roofing and sheet metal trades shall include all operations in sheet metal of ten QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 28rd, 1957, Vol.89, No.8 741 opération exécutée avec «lu métal en feuille, jauge numéro 10 ou plus léger, et toute opération au moyen «l'ardoise, tuiles, asphalte et bardeaux (autres que ceux en bois), de composition, y compris le posage d'amiante gaufré sur les murs antérieurs et couvertures, de divisions «le chambres de toilette, de tablettes en acier et de moustiquaires, chassis, fenêtres et cadres en métal.Les salariés requis «le travailler temporairement dans l'atelier sont rémunérés d'après les faux' réguliers du montage.Article 10.Les opérations dans l'industrie de la construction «le générateurs de vapeur, de bouilloires et de réservoirs comprennent: ii) Tout travail «le montage, d'assemblage, «le démolition ou «le démontage de bouilloires, de montage «l'acier s'y rapportant, la mise en place de l'appareillage sur des bases ou supports, le posage et le roulage des tidies, le posage «le toute partie sous pression ou non (à l'exception du déchargement, du levage ou de la mise en place de bouilloires portatives, «le réservoirs à vapeur et de sections assemblées de bouilloires tubulaires, lesquels doivent être exécutés par le travailleur en fer structural); b) Tout travail se rapportant aux raccords en Y (\"breechings\"), aux réservoirs de fumée, aux cheminées, aux colonnes d'air, aux flotteurs (\"pontoons\"), aux chauffe-eau et aux réchauds, aux fumivorcs, aux réservoirs «le toutes sortes et aux travaux en fer laminé; r) Le montage et la construction de purgeoirs (\"purifying boxes\") «le génératrices à gaz, de cuves de brasseries, «le colonnes d'alimentation (\"standpipes\").d'embranchements (\"penstocks\") et gazomètres; 0) hours per week for hot mastic asphalt kettlemcn; /;) nine (9) hours per day and fifty (oil) hours per week for all other hot mastic asphalt employees; c) eight (8) hours per day and forty-eight (18) hours per week for tunnel work; (I) eight (8) hours per day and forty (10) hours per week for maintenance men who are not permanent employees.Article 17: The maximum hours of work, extending from Monday to Friday included, hut without any specified starting or finishing hours, shall be: a) nine (9) hours per day and forty-five (45) hours per week for common labourers and hod carriers; b) eight (8) hours per day and forty (40) hours per week for cement finishers.1 he-regular work day started on Friday may be completed at single time on Saturday.Single time shall also be paid for waiting from the tune they report as ordered for work to the time of starting work.c) forty (40) hours per week, with \"» limit for daily hours other than ending at 5 p.m.on Friday,* for roofers and built-up membrane roofers other than sheet metal erectors; Article 18: Material checkers, timekeepers, yardmen and night watchmen shall not be QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 743 ne sont pas sujets à une limite dans la durée de leur travail.Les gantions de nuit ont droit à une période de repos de neuf heures suivant chaque période de quinze heures de garde.section 7 \u2014 primes Article 19: Lorsqu'on a recours à des équipes supplémentaires «le salariés, il n'y a pas d'heures fixes pour le commencement ou la cessation du travail d'aucune équipe.Ces équipes supplémentaires «le salariés doivent recevoir un supplément de cinq (5) cents l'heure en plus des taux réguliers.Article 20: Lorsque, pour une raison suffisante, un travail urgent d'altération ou de réparation à un édifice ne peut être exécuté en deçà «les limites horaires régulières, il n'y aura pas d'heure fixe de commencement ou de cessation «le travail pour tout travail «le ce genre.Tous les salariés affectés à un tel travail doivent recevoir un supplément de 80.05 sur les taux réguliers.Cependant, lorsqu'un permis est émis en exécution de la Loi relative à la limitation «les heures de travail, pour cinq (5) nuits consécutives ou plus, les dimanches exceptés, la durée du travail peut être de neuf (9) heures par équipe, le tout ne devant pas exéder quarante-cinq (45) heures par semaine, entre 5.00 heures p.m., le lundi et 8.00 heures a.m.le samedi, au taux «le salaire régulier.Article 21: Un supplément de 80.10 l'heure en sus des taux réguliers doit être versé aux salariés faisant partie «l'une équipe irrégulière île jour, excepté les finisseurs de ciment et les finisseurs en mastic d'asphalte chaud travaillant en périodes intermittentes durant le jour lorsque la moitié ou la majeure partie de la durée de travail tombe en dehors des heures régulières du travail de jour.section 8 \u2014 dispositions spéciales Article 22: Nonobstant toutes les dispositions ci-incluses, la durée du travail demeure soumise à la Loi de la limitation des heures de travail (S.R.Q.1941, ch.105) et aux arrêtés ministériels pris en exécution de cette Loi.Article 23: Aucun employeur n'a le droit de punir ou de menacer de punir, tel que par congédiement ou suspension, directement ou indirectement, un ouvrier qui s'absente «lu chantier un jour de fête religieuse de sa foi.Article 24: Tout salarié se rapportant au travail, qui n'a pas été avisé à l'avance que ses services ne seraient pas requis ou dont la durée du travail est moindre que la durée journalière «le travail, a droit à une rémunération équivalant à au moins trois (3) heures de travail par jour, à moins qu'il ait refusé d'exécuter le travail requis dans son propre métier, ou a moins que les travaux soient suspendus à cause de la température.Article 25: Les heures de travail mentionnées ci-dessus sont basées sur l'heure solaire ou l'heure avancée, suivant l'heure en vigueur dans la localité où les travaux sont exécutés.section 9 \u2014 travail supplémentaire Article 26: Tout travail exécuté par les ouvriers-salariés en plus des heures régulières ou en dehors des limites horaires ci-déterminées est considéré comme un travail supplémentaire.Article 27: \u2014 Salaire et demi: Le travail supplémentaire est payé en taux de salaire et demi.Article 28: \u2014 Salaire double: Tous les salariés qui travaillent entre 10.00 heures p.m.et 8.00 heures a.m.quelque jour que ce soit, sont payés au taux de salaire double sauf ; subject to any limitation as to hours of work.Night watchmen are entitled to a rest period of nine (9) hours following each period of fifteen (15) hours of watching.section 7.\u2014 premiums Article 19: When extra shifts of employees arc engaged, there shall be no specified starting and finishing hours for any shift.Such extra shifts of employees shall be paid the regular wage rates plus a premium of five cents (5c) per hour.Article 20: When, for sufficient reason, urgent alterations or repairs on existing buil lings cannot be executed within the regular hours of work, there shall be no specified starting and finishing hours for all such work.All employees working on such operations shall be paid the regular wage rates plus a premium of five cents (5c) per hour.However, where a permit is issued under the Act Respecting the Limiting of Working Hours for five (5) consecutive nights or more, excluding Sundays, nine (9) hours per shift may be worked, the whole not to exceed forty-five (45) hours per week, between 5 p.m.Monday and 8 a.m.Saturday at single time.Article 21: A premium of ten cents (10c) per hour above the regular rates shall be paid to all workmen, excepting cement finishers and hot mastic asphalt finishers, operating on any broken day shift when half or the major portion of the period of employment falls outside the regular daily hours of work.section 8.\u2014 special provisions Article 22: Notwithstanding anything herein, the duration of work remains subject to the Act.Respecting the Limiting of Working Hours (R.S.Q.1941, Chap.105) and Orders-in-Council enacted thereunder.Article 23: No employer may punish or threaten to punish, by discharge or suspension, directly or indirectly, any employee because he is absent from work on a religious holiday of his faith.Article 24: Any employee reporting for work, who lias not been notified in advance that his services whould not be required, or whose duration of work is less than the regular work day, is entitled to be paid for at least three hours per day, unless he has refused to do the work re- ' quired of him in his own trade, or unless work is suspended on account of weather conditions.Article 25: The hours hereinabove specified shall mean Standard Time or Daylight Saving Time, depending upon which time is in force in the locality where the work is executed.section 9.\u2014 overtime work Article 26: Work performed by employees in excess of the regular hours or outside the limit of hours determined above shall be considered as overtime work.Article 27: Time ami One Half: Overtime work shall be paid at the rate of time and one half.Article 28: Double Time: All-employees who work between2l0 p.m.and 8 a.m.on any day shall be paid at the rate of double time, except; 744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° 8 a) ceux travaillant sur la deuxième et troisième équipes; b) ceux mentionnés aux articles 15, 16 ou 17.Article 29: Tous les salariés qui travaillent entre midi et minuit le samedi sont payés au taux de temps double sauf ceux mentionnés aux articles 15 ci 16.Article 30: Tout salarié qui travaille entre S.00 heures a.m.et minuit le Premier jour de l'An, le Vendredi-Saint, la Saint-Jean-Baptiste, le Jour du Dominion, la fêle du Travail, le jour d'Actions-de-Grûces, Noël et le dimanche, doit être rémunéré au taux de salaire double.Article 31: Les taux de salaire et demi ou salaire double sont calculés par rapport au taux de salaire minimum, iei fixé, ou au taux de salaire effectivement payé, lorsque ce dernier est plus élevé.TITRE QUATRIÈME apprentissage section 10.\u2014 service et entrainement Article 32: Un apprenti doit rendre de bons et loyaux services à son employeur durant sa période d'apprentissage, prenant soin des outils et du matériel fournis par son employeur.L'employeur professionnel doit faire de son mieux pour entraîner ses apparentis dans le métiers de leur choix.Les apprentis qui fréquentent une école technique ou de métier reçoivent des crédits proportionnés à la durée de leurs études et aux résultats de leurs examens.Aucun apprenti ne doit travailler à l'exécution de travaux à contrat à moins qu'il ne soit sous la direction d'un ouvrier qualifié de son métier.Article 33.\u2014 Examens: Tout apprenti doit se soumettre chaque année à un examen devant le Bureau des Examinateurs approprié situé à 5205, rue Parthenais, Montréal, et après chaque examen il reçoit un nouveau carnet d'apprentissage dans lequel son degré de perfectionnement annuel est indiqué et contrôlé.Si un apprenti s'abstient de se soumettre à chaque examen de ce genre, son carnet d'apprentissage sera annulé.Article 84.\u2014 Age: Aucun apprenti ne doit commencer son apprentissage avant d'avoir seize (16) ans ou après avoir dépassé vingt-trois (23) ans, sauf pour les poseurs d'acier d'armature, qui ne doivent pas commencer avant d'avoir seize (16) ans ou après avoir dépassé vingt-cinq (25) ans.Article 35.\u2014 Enregistrement: Tous les noms des apprentis doivent être inscrits dans un registre spécial tenu par le Comité Conjoint des Métiers de la Construction à Montréal.Article 86.\u2014 Proportions: Un employeur professionnel peut employer un apprenti par cinq (5) ouvriers qualifiés, sauf dans les métiers suivants : a) briquetage et posage de lattes de métal où la proportion peut être de deux il cinq respectivement; 6) travail de métal en feuille et couvrage où la proportion peut être de un à trois respectivement.Tout travail urgent ou spécial peut, cependant, pour des raisons jugées suffisantes, être exécuté sur une base d'un (1) apprenti pour chaque équipe de trois ouvriers qualifiés ou fraction de telle équipe; c) le travail de poser des tuiles et des feuilles de linoléum et de muroléum, et la pose de tuiles de composition, où il peut y avoir un aide ou apprenti pour chaque mécanicien sur chaque ouvrage, l'un ou l'autre de ces derniers devant toujours aider au mécanicien.a) those working on second and third shifts; /;) those mentioned in Articles 15, 10 or 17.Article 29: All employees who work between 12 noon and midnight Saturday shall be paid at the rate of double time, except those mentioned in Articles 15 and 16.Article SO: All employees who work between S a.m.and 12 midnight on New Year's Day, Good Friday, St.Jean Baptiste Day, Dominion Day, Labour Day, Thanksgiving Day, Christ mas Day and Sundays, shall be paid at the rat.' of double time.Article SI: The rates of time and one half or double time shall be calculated on the basis of the minimum wage rate established herein, or the wage rate actually paid, whichever to I he higher.FOURTH TITLE apprenticeship section 10.\u2014 service and instruction Article 32: An apprentice shall render good and loyal service to his employer during his period of apprenticeship, taking care of the tools and material furnished by his employer.¦ The professional employer shall do his utmost to instruct bis apprentices in the trades in which they arc working.Apprentices who attend a technical or trade school shall receive credits proportionate to the length of their studies and results of their examinations.No apprentices may do contract work except under the supervision of a qualified worker in his particular trade.Article 33: Examinations: Every apprentice shall submit annually to a progress examination before the appropriate examining board located at 5205 Parthenais street, Montreal, and after each examination shall receive a new apprenticeship book establishing his annual progress.An apprentice who fails to present himself for each such examination shall have his apprenticeship book cancelled.Article 3/,: Age: No apprentice shall begin his apprenticeship before 10 years or after 23 years of age, except for reinforcing steel creel ors, when he shall not begin before 16 years nor after 25 years of age.Article 35: Registry: The names of all apprentices shall be inscribed in a special register kept by the Building Trades Joint Committee in Montreal.Article 36: Ratios: A professional employer may employ one apprentice to each five qualified workers except in the following trades: a) bricklaying and metal latliing where the ratio may be two to five respectively; b) sheet metal and roofing where the ratio may be one to three respectively.Any urgent or special work may, however, for sufficient reason, be performed on the basis of one apprentice for each shift of three qualified workers or fraction thereof.c) linoleum and muroleum rubber tile and sheet laying and polishing, and composition tile laying, where the ratio may be one helper or apprentice to each mechanic on each job, either of whom must always assist the mechanic. 745 Les proportions supra sont calculées sur chaque site de travail.section' 1 1 \u2014 conditions de travail Article 37.\u2014 Heures de travail: Les apprentis ont les mômes heures de travail que les ouvriers qualifiés.Article 38.\u2014 Durée de l'apprentissage: La dune complète de l'apprentissage est comme suit: Métiers: Années Briqucteur.-:.\u2022 \u2022.4 Charpentier, menuisier, mécanicien.4 Maçon.4 Ferblantier, poseur d'ardoise, asphalte et bardeaux.#.\u2022.4 Peintre, peintre au pistolet, vitrier, décorateur .4 Couvreur \u2014 asphalte et gravier, finitions à membrane rpaportée et a couverture à rouleaux.2 Couvreur, métal en feuille, amiante gaufrée, ardoise, et tous autres genres, sauf les types supra.4 Poseur de tuiles et feuilles en linoléum, muroléum et caoutchouc, cireur et polis-seur, et poseur de tuile de composition 2 Mécanicien de générateur de vapeur.4 Finisseur de ciment.3 Poseur d'acier d'armature.1 Poseur de lattes (métal).3 Chaudronnier en construction.4 Une année d'apprentissage consiste en 2,000 heures de travail réel.Article 39.\u2014 Taux de salaires: Les taux de salaires à payer aux apprentis sont les pourcen-tagi s suivants calculés au cent près des salaires minima payables aux ouvriers qualifiés dans leurs met ii rs respectifs: a) Pour les métiers de quatre (4) années d'apprentissage (excepté (b) ci-dessous); 1ère année.50% 2ième année.60% 3ième année.70% ¦liètue année.85% Ii) Mécanicien de générateurs, de vapeur et chaudronnier en construction: 1ère année.\u2022.60% 2ièrae année.*.70% 3ièrae année.80% liémo année.90% Pour les métiers de trois (3) années d'apprentissage: Kre année.50% 2ième année.70% 3ième année.85% '/) Pour les métiers de deux (2) années d'apprentissage: b're année.75% 2ième année.80% \u2022 Les apprentis poseurs d'acier d'armature: 1er semestre.80% 2ième semestre.90% Article 40.\u2014 Renvoi: Un employeur peut congédier ou renvoyer un apprenti pour les raisons habituelles, ou lorsque son travail est insatisfai-s:,: négligé, ou s'il ne respecte pas les coutume- générales du métier.1 iicle 41: Aucun contrat individuel d'appren-tissi v n'est valide à moins d'être conforme aux dispositions mentionnées dans la présente convention.Article 4^: Aucune des dispositions régissant ¦apprentissage ne s'applique aux métiers dont apprentissage et la qualification sont règlements par une loi de cette province.The above ratios shall be calculated on each job site.section 11.\u2014 working conditions Article 37: Hours of Work: Apprentices shall have the same hours of work as qualified workers.Article 38: Period of Apprenticeship: The full period of apprenticeship shall be as follows: Trades: Years Hrieklayer.4 Carpenter, joiner, millwright.4 Mason.4 Sheet metal worker, slate, asphalt and shingle setter.4 Painter, sprayman, glazier, decorator.4 Roofer \u2014 asphalt and gravel, built-up membrane and roll finishings.2 Roofer \u2014 sheet metal corrugated asbestos, slate, tile, and all other types, except the above.4 Linoleum, muroleum and rubber layer (tile and sheet), waxer and polisher, and composition tile layer.2 Steam generator mechanic.4 Cement finisher.3 Reinforcing steel erector.1 Lather (metal).3 Construction boilcrmaker.4 One year of apprenticeship shall consist of 2,000 hours of actual work.Article 80: Wage Rates: Wages payable to apprentices shall be calculated to the nearest cent as the following percentages of the in minium wage rates payable to qualified workers in the respective trades: a) For trades requiring four (4) years of apprenticeship (except for b) hereunder) : 1st year.50% 2nd year.\u2022\u2022.60% 3rd year.70% 4th year.85% b) Steam generating mechanics and construction hoilermakcrs: 1st year____.60% 2nd year.70% 3rd year.80% 4th year.90% c) For trades requiring three (3) years of apprenticeship: 1st year.50% 2ndvear.70% 3rd year.85% d) For trades requiring two (2) years of apprenticeships: 1st year.75% 2nd year.80% e) Apprentices in the trade of reinforcing steel erectors: 1st six months.80% 2nd six months.90% Article 40: Discharge: An employer may lay off or discharge an apprentice for the customary reasons, or whenever his work is unsatisfactory or careless, or if he does not abide by the general customs of the trade.Article 41- No individual apprenticeship contract shall be valid unless it conforms to the provisions herein.Article 4®' No provisions governing apprenticeship shall apply to the trades whose apprenticeship and competency are subject to an Act of this Province. 746 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 février 1957, Tome 89, N° 8 \u2022 TITRE CINQUIÈME conges section 12 \u2014 définitions Article J/8: Dans le présent titre, les termes ci-après mentionnés ont les sens suivants: a) Timbres \u2014 Les marques imprimées ou vignettes émises par la Commisison du Salaire minimum pour représenter les prestations de congé dues par un employeur; b) Période de prestations \u2014 La période s'étendant du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante; c) Livret de congés \u2014 Le livret émis par ladite commission aux fins d'y apposer lesdits timbres durant ladite période de prestations.section 13 \u2014 livrets de congé Article 44' Tout employeur doit obtenir de ladite commission |un livret de congés pour chacun de ses employés) au commencement d'une période de prestations.Les salariés embauchés durant une période de prestations doivent aussitôt remettre à leur employeur leurs livrets de congé ou, s'ils n'en ont pas.leur employeur doit en obtenir un pour eux.L'employeur qui fournit à son salarié un livret de congé peut en déduire le coût du salaire de ce dernier.Article 4'\"'-' Propriété et garde dru livrets de congé: Le livret de congé bien qu'il puisse être en la possession de l'employeur, appartient au salarié et la créance qu'il constate est incessible.Article 40: L'employeur doit conserver le livret de congé de chaque salarié jusqu'à la fin de la période de prestations ou du contrat de travail entre cet employé et son employeur.L'employeur doit remettre sans délai son livret de congé à chacun de ses salariés à la fin «l'une période prestations ou lors de la fin de la période de travail «lesdits salariés chez leur employeur.Article 47: Tout employeur doit apposer à l'échéance de chaque paie «le son salarié, dans le livret «le congé de ce dernier, des timbres pour une valeur égale à ceux pour cent (2%) du montant brut de chaque paie.section 14 \u2014 droits de salarié Article 48: Tout salarié ayant été au service continu d'un employeur durant une période de prestations a droit à la fin de telle période à: a) un congé d'une durée minimum de sept (7) jours consécutifs dans les quatre (4) mois qui suivent la date de la fin de la période de prestations, etc; b) une somme d'argent à réclamer par le salarié et remboursable par ladite commission, ladite somme représentant la valeur des timbres apposés pour la période de prestations dans son livret de congé.Article 49: Tout salarié n'ayant pas été au service continu d'un employeur durant une période de prestations a droit à la fin «le telle période à: a) une rémunération recouvrable comme ci-dessus représentant la valeur «les timbres apposés pour telle périotlc dans son livret de congé.Article 60: Exemption: Les salariés qui bénéficient d'un plan de vacances établi par leur employeur prévoyant des conditions tout aussi avantageuses que celles dont fait mention le présent titre et qui sont employés surtout dans des éta- FIFfH TITLE vacations section 12.\u2014 definitions Article 4%- I\" this title these terms shall have the following meanings: a) Stamps \u2014 The printed marks or stamps issued by the Minimum Wage Commission representing the vacation-with-pay credits payable by an employer; 6) Credit Period \u2014The period extending from the 1st of May of one year to the 30 th of April of the next year; c) Stamp Rook \u2014 The book issued by the said Commission for the purpose of affixing the said stamps in it during the said credit period.section 13.\u2014 stamp hooks Article 44- Every employer shall obtain from the said Commission a stamp book for each of his employees at the beginning of a credit period.Employees hired during a credit period shall hand over their stamp books promptly to the employer, or, if they do not have such a stamp book, the employer shall obtain one for them.The employer who provides his employee with a stamp book may deduct its cost from the employees wages.Article 45: Ownership and Custody of Stamp Boohs: The stamp book, even when in the employer's custody, shall belong to the employee, and the credit shown therein shall not be transferable.Article 46- The employer shall keep each employee's stamp book until the end of the credit period or until such employee's services with the employer are terminated.The employer shall promptly return the stamp book to each one of his employees at the end of a credit period or on the termination of services of such employees for the employer.Article 47: Every employer at the end of each regular pay period shall affix stamps in his employee's stamp book in an amount equivalent to two per cent (2%) of the gross amount of such pay.section 14.\u2014 rights of employees Article 48: Every employee, whose work has been continuous with one employer throughout a credit period, is entitled at the end of such period to: a) a vacation having a minimum duration of seven (7) consecutive days, to be given within four (4) months from the expiry of the credit period, and 6) a sum of money redeemable by the employee as a claim from the said Commission equivalent to the face value of the stamps affixed in his stamp book for the credit period.Article 49- Every employee, whose work lias not been continuous with one employer throughout a credit period, is entitled at the end of such period to : a) a sum of money redeemable as aforesaid equivalent to the face value of the stamps affixed in his stamp book for the credit period.Article 50: Exemption: Employees who participate in a vacation-with-pay plan established by their employer, with conditions not less favourable to such employees than those provided under this title, and who are principally employed in QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 747 blissemcnt manufaeturiés et partiellement à la construction de bâtiments ou à la construction mécanique, ou comme employés permanents préposés à l'entretien, ne sont pas assujettis aux dispositions du présent titre.Article 51: Recouvrement: Lorsqu'un employeur ne se conforme pas à l'une ou à l'autre des obligations sous le présent titre, le salarié a droit à un remboursement, en espèces pour toute rémunération pour congé, lequel remboursement est susceptible de recouvrement par le Comité Conjoint chargé de la mise à exécution de la présente convention comme dans le cas de salaires inférieurs aux taux minima.Cependant, aucun employeur ne peut remplacer les timbres par un paiement direct en espèces au salarié.Article 52: Toute stipulation ayant l'effet d'accorder à un salarié des conditions moins avantageuses que celles prévues par le présent titre sera nulle et non avenue.CHAPITRE FINAL durée de cette extente Article 58: Les présentes parties sont, d'accord pour se rencontrer pas plus\"tard que le 1er novembre, 1957, pour discuter la question d'une augmentation au taux du congé payé et la question du salaire double de samedi matin.Article ô.',: Cette convention expire le 31 mars mil neuf cent cinquante-neuf.L'une ou l'autre des deux parties, désirant modifier une quelconque disposition de la convention doit en avertir l'autre partie par lettre recommandée au moins cinq (5) mois avant son expiration, à défaut de quoi, cette convention sera automatiquement renouvelée et confirmée pour une période supplémentaire d'un an.S'il n'y a pas accord sur les modifications dans les soixante (00) jours dudit avertissement, l'une out l'autre des parties peut avoir recours à la conciliation sous l'égide du Ministère du Travail.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail.Québec, le 23 février 1957.44389-o ]\\Jinistère des Finances Assurances Avis de changement de nom Avis est donné par les présentes que \"North American Casualty and Surety Reinsurance Corporation\", constituée en corporation conformément aux lois de l'État de New York, États-Unis d'Amérique, et enregistrée dans la province \u2022sous le numéro 527, a changé son nom en celui P°u.r l>ch»t de «'00,000.00 d'obligations des commissaires d'éco-Ç pour la municipalité de Ste-Agathe-des-*lonts, comté de Terrebonne, datées du 1er evrier 1957 et remboursables par séries du 1er Tenders Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of Ste-Agathe-des-Monts (County of Terrebonne) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Louis Pellerin, Secretary-Treasurer, 40 Principale Street, Ste-Agathe-des-Monts, county of Terrebonne, until 8.00 o'clock p.m., Wednesday, March 13, 1957, for the purchase of an issue of Si 60,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of Ste-Agathe-des-Monts, county of Terrebonne, dated February 1st, 1957 and redeemable serially from February 1st, 1958 to Feb rua- 750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° 8 février 1958 «au 1er février 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux non inféireur à 4)^% ni supérieur à 5^% par année payable semi-annucllcincnt les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 7 novembre 1950, telle que modifiée \u2014 Construction «l'une t'cole pour filles.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant: ry 1st, 1972 inclusively, with interest at a rate not less than 4^% nor more than 5]/>% per annum, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of inlet rest may be the same for the whole issue or if may vary according to maturities.Loan resolution dated November 7.1956, as amended\u2014\u2022Construction of a school for girls.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from April 1st, 1957.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 8160,000.00 \u2014 Année Capital 1er février 1958.xS 14.500.1er février 1959.x 15.000.1er février 1900.x 10.000.1er février 1901.x 17,000.1er février 1902.x 17,500.1er février 1963 .6.500.1er février 1964 .0,500.1er février 1905.7,000.1er février 1900.7.500.1er février 1907.7,500.1er février 1908.8,000.1er février 1909.8,500.1er février 1970.9,000.1er février 1971.9,500.1er février 1972.10,000.15 ans Table of redemption \u2014 Year 00 February 1st, 195S.00 Februarv 1st.1959.00 Februarv 1st, 1900.00 February 1st, 1961 .00 February 1st, 1902.00 Februarv 1st.1963.00 February 1st, 1964.00 February 1st, 1905.00 Februarv 1st, 1906.00 Februarv 1st, 1967.00 \u2022 February 1st, 1908.00 February 1st, 1969.00 February 1st, 1970.00 Februarv 1st, 1971 .00 Februarv 1st, 1972.8160,000.00 \u2014 15 nears Capital .x$14,500.00 .x 15.000.00 .x 16,000.00 .x 17,000.00 .x 17.500.00 .6,500.00 .6,500.00 .'.7,000.00 .7,500.00 .7.500.00 .8.000.00 .8,500.00 .9,000.00 .9,500 00 .10,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant.lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 860,661.25, accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de 812,132.25 chacun, de 195S à 1962 inclusivement, seront, reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Stc-Agathe-des-Monts, comté de Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Ste-Agathe-des-Monts, comté de Terrebonne.Lesdites obligations ne seront pas rachctablcs par anticipation avant le 1er février 1965 inclusivement; après celte date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus.de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Charpie soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 13 mars 1957, à 8.00 heures p.m., au bureau du secrétaire-trésorier, 40 rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts, comté de Terrebonne.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni acune des soumissions.Ste-Agathe-des-Monts, (Comté de Terrebonne), ce 21 février 1957.Le Secrétaire-trésorier, LOUIS PELLERIN.Adresse postale: CP.300, 40, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts, (Comté de Terrebonne), P.Q, 44401-o The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $60,661.25, granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of 812,132.25 each, from' 1958 to 1962 inclusively, shall be received and applied to the service of thjg said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any.by certified cheque payable at par at Ste-Agathe-des-Monts, county of Terrebonne.Capital and interest are payable at the hank mentioned in the loan procedure at Montreal.Quebec or at Ste-Agathe-des-Monts, county of Terrebonne.The said bonds are not redeemable by anticipation before February 1st, 1965 inclusively; after this date, the said bonds arc.under the authority of Chapter 212.Revised Statutes of Quebec.1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par.at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of hialurity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, March 13, 1957, at 8.00 o'clock p.m., at\" the office of the Secretary-Treasurer, 40 Principale Street, Ste-Agathe-des-Monts, county of Terrebonne.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Ste-Agathe-des-Monts, (County of Terrebonne), February 21, 1957.LOUIS PELLERIN, Secretary-Treasurer.Postal Address, P.O.B.300, 40, Principal Street, Ste-Agathe-des-Monts, .nl (County of Terrebonne) P.Q.44401 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 751 Province 4 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q:.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés paur satisfaire bu paiement des arrérages de taxes dues à la cite de Chicoutimi et à la commission scolaire, Jjvec intérêts et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public.Province of Quebec City ok Chicoutimi Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by a decree dated the fifteenth day of February 1957, ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act(R.S.Q 1941, chapter 207) to sell the immoveables here-inunder described in payment of taxation arrears owing to the city of Chicoutimi and School Commission, with interest and costs, and that consequently, the said immoveables shall be sold by public auction, in the council room, at the 758 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° S dans la salle du conseil, à l'hôtcl-de-ville de Chicoutimi, le VINGT MARS 1957.à ONZE heures de Pava ut-midi.Toutefois, pourront être exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales échues le ou avant le 31 décembre 1955 et les taxes scolaires échues le ou avant le30 juin 1956 auront été payées avant le moment de la vente.1.Peter Hudson \u2014 Un terrain mesurant 50 pieds de largeur sur 100 pieds de profondeur, le tout plus ou moins, comprenant les lots 982-1 et 983-2 et on plus toute cette partie non subdivisée des lots 984 et 982 nécessaires pour former tel que susdit un terrain d'une largeur do 50 pieds par une pronfondeur de 100 pieds, cesdites parties de lots non subdivisées bornées au nord aux lots 984-2 et 9S2-1; vers l'ouest au lot 984-1; vers l'est et vers le sud a J.Edgar Perron ou représentants.2.Adrien Tremblay \u2014 Le lot 000-1.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Lesdits lots et parties de lots sont du cadastre officiel de la ville de Chicoutimi.Us seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en a.sujet à tous les droits acquis par la cité de Chicoutimi et à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes pouvant les affecter.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et.aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Qtmhec.Donné à Chicoutimi, ce I9ème jour de février 1957.Le Greffier, 443S7-S-2-0 GASTON CARRIER.city hall of Chicoutimi.the TWENTIETH day of MARCH 1957, at ELEVEN o'clock in the forenoon.However, there may be excluded from the sale the immoveables on which the municipal taxes due on or about December 31, 1955 and school taxes due on or about June 30, 1950, which shall have been paid before the time of the sale 1.Peter Hudson \u2014 A piece of land mesauring 50 feet in width by\" 100 feet in depth, all of which more or less, including lots 982-1 and 983-2 plus all that misub-divided portion of lots 984 and 982 required to form as mentioned above, a piece of land of 50 feet wide mid 100 feet deep, the said portions of unsubdivided lots bounded northerly by lots 9S4-2 and 982-1; westerly by lot 984-1 ; easterly and southerly by J.Edgar Perron or representatives.2.Adrien Tremblay \u2014 Lot 000-1.The adju iication price of each one of these immoveables shall be payable imme 'i itch .The saiil lots and parts thereof arc of the official cadastre of the town of Chicoutimi.They shall be sold with buil lings erecte I the-reon, circumstances and depen lencies, if any, subject to all rights acquired by the city of Chicoutimi and servitudes both active and passive, apparent and unapparent affecting them.The sale shall moreover b?subject to a right of re lemption and to the other provisi wis of the Quebec Municipal Commission Act.Given at Chicoutimi, this 19th, day of February, 1957.GASTON CARRIEII.44387-8-2 F Clerk.ERRATUM municipalité do comté de papineau Dans l'avis de vente de terrains pour taxes, paru dans la Gazette officielle de Québec, les 19 et 26 janvier 1957,-erreur a été commise, dans la municipalité du canton d'Amherst.Au lieu de lire comme suit: P.1, rang 5 S, canton d'Amherst, taxes $38.04, propriétaire, Gustave Racicot On devra lire ainsi: % sud 1.rang 5 sud.canton d'Amherst, taxes $38.04, propriétaire, Les héritiers légaux enregistrés de feu Gustave Racicot Papincauville, ce 18 janvier 1957.Le Secrétaire-trésorier, 44375-0 ALBERT ROULAIS.ERRATUM ?Municipality of the county of Papineau Li the notice for sale of hinds for taxes published in the Quebec Official Gazette, the 19th and 26th of January 1957, error has been made in the municipality of the township of Amherst.Instead of reading as follows: P.1, range 5 S.,township of Amherst, taxes $38.04,.owner Gustave Racicot.One must read as follows: ]/2 south 1, range 5 south, township of Amherst, taxes $38.04, owner, The legal registered heirs of the late Gustave Racicot.Papincauville, Februarv 18th, 1957.ALBERT BOULAIS.44375-0 Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHERLFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le présent donné que PUBLIC NOTICE is hereby given that the les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus has.ive times and places mentioned below.ABITIBI Canada, Province de Québec District d'Abitibi Cour de Magistrat, N° 15,400./ TOS.A.D < J dustricl (de Val d'( DUFRESNE, in-riel et commerçant Or et y faisant affaires sous la raison sociale de \"Jos.A.Dufresne Enrg.\" demandeur saisissant vs EDGAR LE-FEBVRE, de Val d'Or, défendeur saisi.AVIS DE VENTE ABITIBI Canada, Province of Quebec District of Abitibi Magistrate's Court, ( TOS A.DUFRESNE, in-No.15,460.< J dustrialist and merch-lant of Val d'Or and carrying on business therein under the firm naine ot \"Jos.A.Dufresne Enrg.\", distraining plaintiff vs EDGAR LEFEBVRE, of Val d'Or, defendant distrained.NOTICE OF SALE L'immeuble connu et désigné comme étant The immoveable known and designated as une maison de vingt par 30 (20 x 30) avec dépen- being a house of 20 by 30 (20 x 30) with depen- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 759 dances en arrière de la maison le tout érigé sur un terrain appartenant à la Northern Townsite Corporation de Val d'Or, et construite sur une me connue comme étant le boulevard Lamaque.Cette partie du lot n'est pas cadastrée.Cette maison a un étage avec devanture peinte en blanc et bleu.Pour être vendue à la porte de l'église paroissial, de St-Sauveur de Val d'Or, le VINGT-HUIT MARS 1957 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi.Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos.13 février 1957.44383-8-2-0 ARTHABASKA Canada \u2014 Province de Québec District d'Arthahaska Cour Supérieure, c JOSEPH BROUILLARD, N° 12,105.< J cultivateur, de St-Aimé, v district de Richelieu, demandeur; vs EMILE COUTU ET CLOVIS LE-CLERC, de Drummondvillc.district d'Arthabaska, défendeurs; et LE RÉGISTRATEUR Dl COMTÉ DE DRUMMOND, mis-en-cause.Deux lots avec toutes les bâtisses dessus construites, connus et désignés aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Grantham, sous le numéro vingt-sept et vingt-huit des subdivisions officielles du lot numéro cent vingtaniatre.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale Saint-Frédéric, Drummondvillc JEUDI, VINGT-HUITIÈME jour de MARS 1957.à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, FÉLIX HOULE.Arlhabaska, le 18 février 1957.44397-8-2-o dencies in the rear of the house, all of which erected on a piece of land belonging to the Northern Townsite Corporation of Val d'Or, and situated on a street known as Boulevard Lamaque.That part of lot is not registered.Said bouse is of one storey with front part of house painted in blue and white.To be sold at the door of the Parochial Church of St.Sauveur de Val d'Or, the TWENTY-EIGHTH day of MARCH 1957, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office.Sheriff.Amos.February 13, 1957.44383-8-2 ARTHABASKA Canada \u2014 Province of Quebec District of Arthahaska Superior Court./ JOSEPH BROUILLARD, No.12.105.< J farmer, of St.Aimé, dis-Itrict of Richelieu, plaintiff; vs EMILE COUTU AND CLOVIS LECLERC, of Drummondvillc.district of Arthahaska, defendants; ami THE REGISTRAR OF THE COUNTY OF DRUMMOND, mis-cn-cause.Two lots with all the buil lings erected thereon, known and designated on the official plan and book of reference of the cadastre of the township of ( Ira nt ha in.under number twenty-seven and twenty-eight of the official subdivisions of lot number twenty-four.To be soil at the door of the parochial church of St.Frédéric.Drummondvillc.THURSDAY, the TWENTY-EIGHTH day of MARCH, 1957, at THREE o'clock in the afternoon.FÉLIX HOULE, Sheriffs Office, Sheriff.Arthahaska.Februarv 18, 1957.44397-8-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour Supérieure, I JGNACE LANGEAIS, com-N° 18454.< *¦ merçant de bois, de St-' Pascal, demandeur vs ERNEST BÉLANGER, rentier de St-Pascal.défendeur.\"Un terrain situé dans le village de St-Pascal, comté de Kamouraska, contenant environ 35 pieds est-ouest de largeur par environ 170 pieds de longueur (mesure anglaise), borné au nord à une nie.au sud, à Philippe Desjardins, au nord-est, à un chemin réservé, et au sud-ouest, à Jos Lan-gclier.avec maison dessus construite, circonstances et dépendances, lequel terrain fait partie du lot de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du comté de Kamouraska, pour ladite paroisse de St-Pascal, sous le numéro deux cent soixante-et-onze (pt.271).\" Pour être vendu à la porte de l'église de St-Jascal.comté de Kamouraska, MARDI le VWGT-SDCIÊME (26) jour de MARS 1957, u l'El.X heures de l'après-midi, heure avancée.\u201e Le Shérif, Bureau du Shérif, P.-E.MARTIN.Iliviére-du-Loup, 19 février 1957.44398-8-2-o Ureiniére insertion: samedi, le 23 février 1957.] KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Superior Court, / JGNACE LANGLAIS, lum-No.18454.< *¦ her merchant, of St.Pas-Ical, plaintifr vs ERNEST BÉLANGER, annuitant of St.Pascal, defendant.A piece of land situated in the village of St.Pascal, county of Kamouraska, containing some 35 feet east-west in width by some 170 feet in length (English measure), bounded northerly by a street, southerly by Philippe Desjardins, northeasterly by a reserved road, and southwesterly, by Jos.Langelier, with house erected thereon, circumstances and dependencies, which land forming part of lot of land known and designated on the official plan and book of reference of the cadastre of the county of Kamouraska, for the said parish of St.Pascal, under number two hundred and seventy-one (No.271).\" To be sold at the door of the church of St.Pascal, county of Kamouraska, TUESDAY, the TWENTY-SIXTH (26th) day of MARCH 1957, at TWO o'clock in the afternoon, Daylight Saving Time.P.-E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, February 19, 1957.44398-8-2 [First, insertion: Saturday, February 23, 1957.J 760 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tonte 89, N° S LABELLE Fieri Faria.* Canada, \u2014 Province de Québec District de Labelle Cour Supérieure, ( T 'OFFICE DU CRÉDIT N°4753.< ^ AGRICOLE DU QUÉBEC, corps politique et incorporé ayant son siège social à Québec, demandeur, vs ALFRED PATRY, de Messines, comté de Gatineau, défendeur.Savoir: \"1° Le lot de terre portant le numéro quarante-trois (43) dans le rang cinq (rg.5) du canton de Bouchette; 2° Le lot de terre portant le numéro quarante-deux (42) dans le rang (rg.5) du canton de Bouchette, moins deux acres de terre appartenant à The Ottawa Northern Western Railway Company; 3° Le lot de terre portant le numéro trente-neuf (39) dans le rang six (rg.6) du canton de Bouchette, moins: o) Un emplacement d'un arpent carré à être pris dans le coin nord-ouest dudit lot antérieurement, vendu: b) Les parties de ce lot appartenant à Frédéric D.Hogg suivant actes enregistrés au Bureau d'enregistrement de Hull sous les numéros B12/11196.B22/22297 et suivant actes enregistrés au Bureau d'enregistrement de Gatineau sous les numéros B6/4671, B6/4672 et B9/7064.Le tout avec bâtisses y érigées, ci rcor stances et dépendances, et avec toutes les servitudes actives et.passives apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles\".Pour être vendus en bloc, à la porte de l'église {paroissiale de Messine, comté de Gatineau.dans e district de Labelle.le QUINZE (15)ième jour de MARS 1957.A DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, ADRIEN LARCSE.Mont-Laurier, 30 janvier 1957.44241-5-2-o Canada, Province de Québec District de Labelle Cour Supérieure, / T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 4795.< -L» AGRICOLE DU QUÉ-l BEC', corps politique, et incorporé ayant son siège soeial à Québec, demandeur, vs MAXIMILIEN LARENTE, de Mont-St-Michel, Co.Labelle, défendeur.Les lots de terre connus et désignés sous les numéros trente-huit et quarante-un (38 & 41) du rang un (1) aux plan et livre de renvoi officiel du canton Moreau, avec les bâtisses y érigées\".Pour être vendus en bloc, à la porté de l'église paroissiale de Mont-St-Michel Co.Labelle, le TROISIÈME jour d'AVRIL 1957.à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ADRIEN LAROSE.Mont-Laurier, 19 février 1957.44399-S-2-o MONTMAGNY Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, \u2014 Province de Québec District de Montmagny Cour Supérieure, ( T A CAISSE POPULAIRE .N° 7366.< ¦L' DE ST-PIERRE-DU-\\ SUD, corporation légalement constituée suivant la loi des Syndicats Coopératifs, ayant son siège social à St-Pierre, comté LABELLE Fieri Facias Canada, \u2014 Province of Quebec District, of Labelle Superior Court, f f^UEBEC FARM CRE-No.4753.-j ML .DIT BUREAU, a body a Tuque, P.Q.en vertu «l'un jugement rendu par l'Honorable Juge Oscar Boulanger, de la Cour Supérieure, le 26 août 1942, N° 44028, demanderesse, vs GÉRARD AUBIN, dit MIGNAULT.mécanicien, de Ste-Clairc, Dorchester, défendeur.\"Une terre située sur le 4icmc rang du canton de Maddington, en la paroisse de Ste-Maric de Biandford, étant le quart central du lot numéro neuf dudit rang, contenant deux arpents et un quart de largeur sur qunrante arpents de profondeur, étant le quart central du lot de terre numéro trois cent trente-sept 0/i C.de 337) du cadastre officiel pour Ste-Gertrude, dans la partie qui a été annexée à ladite paroisse de Ste-Marie de Biandford, le tout avec la maison et autres bâtisses y érigées, borné en front au sud-est par le chemin publie, en profondeur par l'ancienne ligne de division de la paroisse, au nord-est par le terrain d'Edouard Mailhot, et au sud-ouest par Georges Dorion, circonstances et dépendances; avec en outre les instruments oratoires, tout ce qu'il y a sur le terrain et dans les bâtisses, notamment semoir, herse à disque, herse à ressort, faucheuse, charme, voitures d'été, doublc-seligh, le foin, paille.Tel que le tout se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes attachées à cet immeuble.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Ste-Marie de Biandford, le VINGT-SEPTIÈME jour de MARS (1957) à ONZE heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ANTONIO BLONDIN.Nicolet 18 février 1957.44384-8-2-o NICOLET Fieri Facias de Terris Canada, Province ol Quebec District of Quebec, Beauce and Nicolet Superior Court, No.82,174 l St.A ïAME MARIE ANNE BOUTIN, housewife of Anselme, Dorchester, wife separate as to bed and board of Mr.Evangéliste Laroehelle, of La Tuque, P.Q., under judgment rendered by the Honourable Judge Oscar boulanger, of the Superior Court, on August 26, 1942, No.44028.plaintiff, vs GÉRARD AUBIN, said MIGNAULT, mechanic, of Ste.Claire, Dorchester, defendant.¦ A farm situated on the 4th range of the township of Maddington, in the parish of Ste.Marieof Biandford, being central quarter of lot number nine of the said range, containing two arpents and one quarter in width by forty arpenta in depth, being the central quarter of lot of land number three hundred and thirty-seven (\\$ C.of 337) of the official cadastre for Ste.Gertrude, in the part which was annexed to the said parish of Ste.Marie of Biandford, the whole with house and other buildings thereon erected, bounded in front, on the southeast by the public highway, in depth, by the old dividing line of the parish, on the northeast, by the land of Edouard Mailhot, and on the southwest, by Georges Dorion, circumstances an 1 dependencies; with, over and above the farming implements, all that there may be on the grounds and in the buildings, notably the seeder, disc harrow, spiring harrow, moving-machine, plough, summer carriages, double-sleigh, the hay, straw.As the whoic presently stands, with the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to this immoveable.To be sold at the parochial church door of Ste.Marie of Biandford, on the TWENTY-SEVENTH day of MARCH (1957) at ELEVEN o'clock in the forenoon.ANTONIO BLONDIN.Sheriff's Office, Sheriff.Nicolet, February 18, 1957.44384-8-2 QUEBEC QUÉBEC Fieri Facias Fieri Facias Québec, à savoir: / A LEXANDRE BEAU- Quebec, to wit:/ A LEXANDRE BEAU-N° 85,040.LIEU, garagiste de No.85,040.< LUEU, garage-keeper of I Charlesbourg, comté de Que- v Charlesbourg, county of Quebec, contre EUDORE GIROUX, de Notre- bee, versus EUDORE GIROUX, of Notre-Dame des Laurent ides, comté de Québec.Dame des Laurentides, county of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February SSrd, 1957, Vol.89, No.8 763 Un emplacement mesurant soixante et quinze pieds (75') de largeur sur le chemin appelé Route des Dames, lesdits soixanteetquinzepicds(75')à être calculés à partir du chemin d'hiver de Edouard Fortier ou ses représentants, dans une direction est, sur une profondeur de cent pieds (100'); ce terrain qui est une partie du lot numéro quatre cent quarante-neuf (P.N° 449) du cadastre de Charlesbourg, est borné au sud par la Route des Dames, à l'ouest par le chemin d'hiver de Edouard Fortier ou ses représentants, au nord et à l'est par d'autres parties du lot numéro quatre cent quarante-neuf (P.N° 449) appartenant à Edouard Fortier ou ses représentants tel que le tout est actuellement avec les servitudes actives et passives sans réserve aucune, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; l'n morceau de terrain faisant partie du lot numéro quatre cent quarante-neuf (P.N° 449) de Charlesbourg, situé juste à l'arrière du terrain que l'acquéreur a acheté le 18 mai 1946, de M.Lomer Jacques et qui est aussi une partie du lot numéro quatre cent quarante-neuf (P.N° 449) de Charlesbourg, mesurant soixante et quinze pieds (75') de largeur sur soixante pieds (60') de profondeur et orné comme suit: en front au sud par le terrain de l'acquéreur, au nord et à l'est par le vendeur et à l'ouest par un chemin appartenant aussi au vendeur, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de Notre-Dame des Laurentides, comté de Québec, le HUITIÈME jour de MARS prochain, â DIX heures de l'avant-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, ALBERT F.RACETTE.Québec, le 31 janvier 1957.44251-5-2-o [Première insertion: 2 février 1957.] [Deuxième insertion: 23 février 1957.] An emplacement measuring seventy-five fees (75') in width along the road called Route det Dames, the said seventy-five (75') feet to be calculated as from the winter road of Edouard Fortier or his representatives, in an easterly direction, at a depth of one hundred feet (100'); this land being a part of lot number four hundred and forty-nine (P.No.449) of the cadastre of Charlesbourg, is bounded southerly by Route des Dames, westerly by Edouard Fortier's winter road or his representatives, northerly and easterly by other parts of lot number four hundred and forty-nine (P.No.449) belonging to Edouard Fortier or his representatives such as the whole actually stands with active and passive servitudes without reserve whatsoever, including buildings erected thereon, circumstances and dependencies.A pice of land forming part of lot number four hundred and forty-nine (P.No.449) of Charlesbourg situated in the rear of the land bought by the purchaser May 18, 1946, from Mr.Lomer Jacques and that is also a part of lot number four hundred and forty-nine (P.449) of Charlesbourg, measuring seventy-five feet (75') in width by sixty feet (60') in depth and bounded as follows: in front to the south by the land of the purchaser, northerly and easterly by the vendor and westerly by the road belonging also to the vendor, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the Parochial Church of Notre-Dame des Laurentides, county of Quebec, the EIGHTH day of MARCH next at TEN o'clock in the forenoon.ALBERT F.RACETTE, Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Quebec, January 31, 1937.44251-5-2 [First insertion: February 2, 1957.] [Second insertion: February 23, 1957.] ROBERVAL Fieri Facias Canada, \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure, / piERRE DUMAIS, culti-N° 15,181.\\ ¦*» vateur de la paroisse de v St-François de Sales, demandeur vs ADRIEN LAVOIE, autrefois cultivateur de Dequen-Nord, défendeur.«) La juste moitié nord du lot connu et désigné sous le numéro neuf N.9) du septième rang, aux plan et livre de renvoi officiel du cadastre du canton Charlevoix, avec appartenances et dépendances, bornée vers l'est par le chemin public de front, vers l'ouest par le sixième rang dudit canton, vers le nord par le lot numéro dix desdits rang et canton, et vers le sud par la demie sud du même lot.6) Les lots de terres connus et désignés sous les numéros six-A et six-B (6-A et 6-B) du premier rang aux jïlan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton Dablon, contenant ensemble environ cent acres en superficie, avec appartenances et dépendances, sauf à distraire les parties d'iceux appartenant à et possédées par la Corporation Municipale de Saint-Fran-Çois de Sales ou représentants, et sauf réserve de la servitude de passage de ligne de transmisse0\" d'énergie électrique créée en faveur de la Cie Électrique du Saguenay.Pour être vendus à la porte de l'église de St-François de Sales, comté de Roberval, Province de Québec, le SEPTIÈME jour de MARS mil ROBERVAL Fieri Facias Canada, \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, / piERRE DUMAIS, farmer No.15,181.< * of the parish of St.\\ François de Sales, plaintiff vs ADRIEN LAVOIE, formerly a farmer of Dequen-North, defendant.a) The exact northerly half of lot known and designated under number nine (Yi N.9) range seven, of the official plan and book of reference of the cadastre of the township of Charlevoix, with appurtenances and dependencies, bounded easterly by the fronting public highway, westerly by range sixth of said township, northerly by lot number ten of the said range and township, and southerly by the south half of the same lot.b) Lots of land known and designated under numbers six-A and six-B (6-A and 6-B) of range one of the official plan and book of reference of the cadastre for the township of Dablon, containing together an area of some one hundred acres, with appurtenances and dependencies, save and except those parts thereof belonging to and held by the Municipal Corporation of Saint François de Sales or representatives, and the servitude of right-of-way for the electric power transmission line in favour of \"La Cie Électrique du Saguenay\".To be sold at the door of the church of St.François de Sales, county of Roberval, Province of Quebec, the SEVENTH day of MARCH, one 764 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 février 1957, Tome 89, N° 8 neuf cent cinquante-sept, à DEUX (2) heures de l'après-midi.Le Shérif du District de Roherval.Bureau du Shérif, LÉON-MAURICE LAVOIE.Palais de Justice, District de Roberval, ce 29 janvier, 1957.44243-5-2-0 [Première insertion: samedi le 2 février, 1957.J Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure, 1 T ÉO SIMARD LTÉE, dc-N° 18,879.< ¦»-' mandeur vs FÉLIX JU- l NEAU, défendeur.A titre de possesseur \"Anima domini.\" a) \"Un terrain ou emplacement sis et situés en la Ville d'Alma, avec toutes les bâtisses y érigées, faisant partie du lot numéro quinze-A (ptic N° 15-A), du rang neuf (9), au cadastre officiel du canton Signai, mesurant trente-six pieds vers l'est, quatre-vingt pieds vers le sud, cinquante pieds vers l'ouest et environ soixante-dix pieds vers le nord et borné comme suit: vers l'est à la ligne de division des lots numéros quinze-A et quatorzc-A; vers le sud à une rue (rue Verrcault); vers le nord au terrain des représentants de Madame Clodia Desbiens ou plus spécialement au terrain ci-après décrit, et vers l'ouest au terrain appartenant aux représentants d'Albert.Pilote.\" b) \"Un lopin de terre ou emplacement sis et situé en la Ville d'Alma.mesurant soixante-quinze pieds au sud; quarante-huit pieds au nord, quarante-trois pieds à l'est et quarante-et-un pieds à l'est et quarante-et-un pieds à l'ouest, faisant partie du lot numéro quinze-C (ptie N° 15-C), du rang neuf (9), au cadastre officiel du canton Signai, sans bâtisses et borné comme suit: au nord au terrain d'Oscar Harveu; au sud à celui ci-dessus décrit arboutant à la rue Verrcault; à l'est au terrain des représentants de Célestin et Elzéar Potvin et à l'ouest au résidu du terrain appartenant au Docteur L.M.Michaud ou représentants.A distraire, les servitudes de baignage.\" Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse du Sacré-Cœur, Ville d'Alma, district de Roberval, comté Lac St-Jean, le VINGT-HUITIÈME jour de MARS, mil neuf cent cinquante-sept, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif du District de Roberval, LÉON-MAURICE LAVOIE.Bureau du Shérif, Palais de Justice, district de Roberval, Ce 18 février, 1957.44385-8-2-o [Première insertion: samedi le 23 février, 1957.J SAGUENAY Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay Cour Supérieure, / T ES PÉTROLES INC., N° 9305.S corps politique incorporé, \\ ayant son siège social à Sillery, district \"de Québec, demandeur, vs ANGELO DUFOUR, résidant à St-Bernard-sur-Mer dans le comté de Charlevoix, district de Saguenay, défendeur.Un emplacement situé à lTle-Aux-Coudres mesurant 50 pieds de largeur sur 145 de profondeur mesure anglaise, étant et formant partie du lot N° 3 au cadastre officiel de l'Ile-aux-Coudres borné en front au chemin public, en arrière et au thousand nine hundred and fifty-seven, at TWO o'clock in the afternoon.LEON-MAURICE LAVOIE.Sheriff's Office, Sheriff of the District of Roberval.Court House, District of Roberval, this January 29, 1957.44243-5-2 [First insertion: Saturday, February 2, 1957.] Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada, \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, ( T ÉO SIMARD LT EE, No.18,879.< -L* plaintiff, vs FÉLIX JU- l NEAU, defendant.By ownership title \"Animo domini\".a) \"A lot of land or emplacement situated in the town of Alma, with all the buildings thereon erected, forming part of lot number fifteen-A (Pt.No.15-A), of range nine (9), of the official cadastre of the township Signai, measuring thirty-six feet on the east, eighty feet on the south, fifty feet on the west and about seventy feet on the nort and bounded as follows: on the cast, by the dividing line of lots numbers fifteen-A and fourteen-A; on the south, by a street (Verreault street); on the north, by the land of the representatives of Mrs.Clodia Desbiens or more particularly by the land hereinafter described, and on the west, bv the land belonging to the representatives of Albert Pilote.\" b) \"A strip of land or en placement situated in the town of Alma, measuring seventy-five feet on the south; forty-eight feet on the north, forty-three feet on the east and forty-one feet on the cast and forty-one feet on the west, forming part of lot number fifteen-C (Pt.No.15-C), of the ninth range (9), of the official cadastre of the township Signai, without buildings and bounded as follows: on the north, by the land of Oscar Harvcu; on the south, to that hereinabove described abutting on Verreault street; on the east, by the land !' the representatives of Celestin and Elzéar Pol vin and on the west, by the residue of the land belonging to Doctor L.M.Michaud or representatives.To withdraw, the bathing servitudes.\" To be sold at the door of the church of the parish of \"Sacré-Coeur\", town of Alma, district of Roberval, county of Lake St.John, on the TWENTY-EIGHTH day of MARCH, one thousand nine hundred and fifty-seven, at TWO o'clock on the afternoon.LÉON-MAURICE LAVOIE, Sheriff of the District of Roberval.Court House, district of Roberval, This February 18th, 1957.44385-8-2 [First insertion: Saturday, February 23, 1057.} SAGUENAY Canada \u2014 Province of Quebec District of Saguenay Superior Court, ( T ES PÉTROLES INC., a No.9305.< body politic and corpo-Irate, having its place of business in Sillery, district of Quebec, plaintiff, vs ANGELO DUFOUR, residing at St-Hernard-sur-Mer, in the county of Charlevoix, district of Saguenay, defendant.An emplacement situated at Ue-Aux-Coudres, measuring 50 feet in width by 145 in depth, English measure, being and forming part °' lot No.3 of the official cadastre of Ile-Aux-Coudres, bounded in front by the public highway, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 765 sud-ouest par le terrain de Samuel Desgagné et au nord-est par les représentants de Urbain Dufour avec bâtisses construites dessus, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Bcrnard-sur-Mer, MARDI le DIX-NEUVIÈME jour de MARS à DEUX heures de l'après-midi.Fait et signé à La Malbaie, ce 28ième jour de janvier 1957.Le Shérif, 44227-5-2-0 PIERRE NÉRON.in rear and on the southwest, by the land of Samuel Desgagné and on the northeast by the representatives of Urbain Dufour, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of St-Bernard-sur-Mer, TUESDAY, the NINETEENTH day of MARCH, at TWO o'clock in the afternoon.Made and signed at La Malbaic, this 28th day of January, 1957.PIERRE NÉRON, 44227-5-2 Sheriff.SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District de St-François Cour Supérieure.( pl ABRIEL DUBREUIL, N° 15,697.< VJT commerçant de Shcr-' hrooke, district de St-François, demandeur, vs STANISLAS CLOUTIER, domicilié à 190 sud, 8ièinc Avenue, à Sherbrooke, district de St-François, défendeur.Comme appartenant audit défendeur: \"L'immeuble suivant: \"La redivision dix de la subdivision neuf du lot originaire N° douze (12-9-10).Dans le deuxième rang (2e) au cadastre du canton de Westbury.dans la ville d'East-Angus, avec bâtisses dessus construites et dépendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de S -Louis de Westburv.(East-Angus), MERCREDI, VINGT-SEPTIÈME jour de MARS 1957, à DIX heures a.m.IiO Sli ' rif Bureau du Shérif, JOSEPH LABRECQUE.Sherbrooke, ce 19 février 1957.44386-8-2-0 i Première insertion: le 23 février 1957] Index de la Gazette officielle de Québec, N°8 Actions en séparation de biens: Marchand vs Cinq-Mars.726 Savard vs Morin.726 Avis aux intéresses: 692 Avis divers: SAINT FRANCIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District of St.Francis Superior Court, /p ABRIEL DUBREUIL, No.15,697.< VJ trader of Sherbrooke, (.district of St-Franeis.plaintiff, vs STANISLAS CLOUTIER, domiciled at 190 south, 8th Avenue, at Sherbrooke, district of St-Francis, defendant.As belonging to the said defendant: \"The following immovable: \"The redivision ten of the subdivision nine of the primitive lot No.twelve (12-9-10), in the second range (2) on the cadastre of the township of Westbury, in the town of East-Angus, with buildings thereon erected and dependences.\" To be sold at the door of the parochial church of St-Louis dc Westburv (East-Angus).WEDNESDAY, the TWENTY-SEVENTH of MARCH 1957, at TEN in the forenoon.JOSEPH LABRECQUE, Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, February 19th.1957.44386-8-2-0 [First insertion: the 23rd of February 1957] lodex of the Quebec Official Gazette, No.8 Actions for Separation as to Property: Marchand vs Cinq-Mars.726 Savard vs Morin.726 Notice to Interested Parties: 692 Miscellaneous Notices: Association des Cardiologues de la Province de Québec \u2014 Association of Cardiologists of the Province of Quebec (Règlements).724 Association des Clubs de Ski de Montreal (Règlements).____ 721 Association des Conseillers d'Orientation Professionnelle de la Province de Québec (Règlements).724 Association des Instituteurs et Institu- trics de LTslet-Sud (Formation).724 Beatty Clothing Mfg.Co.(Directeurs).725 Corporation de Prêt et Revenu \u2014 Savings and Investment Conjuration (Directeurs) .723 Jugar Corp.(Directeurs).725 E.H.Lemay, Limited (Directeurs).721 J.& E.Hall Limited (Agent).722 L'Association des Instituteurs et Institutrices Catholiques du comté de LTslet-Nord (Nom changé).722 Les Ouvriers Unis dc Grand Footwear Inc.(Formation).724 Association des Cardiologues de la Province de Québec \u2014 Association of Cardiologists of the Province of Quebec (By-law).724 Association des Clubs de Ski de Montréal (By-laws).721 Association des Conseillers d'Orientation Professionnelle de la Province de Québec (By-law).724 Association des Instituteurs et Institutrices de LTslet-Sud (Formation).724 Beatty Clothing Mfg.Co.(Directors).725 Corporation de Prêt et Revenu \u2014 Savings and Investment Corporation (Directors) .723 Dugar Corp.(Directors).725 E.H.Lemay, Limited (Directors).721 J.& E.Hall Limited (Agent).722 L'Association des Instituteurs et Institutrices Catholiques du comté de LTslet-Nord (Name changed).722 Les Ouvriers Unis de Grand Footwear Inc.(Formation).724 766 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1951, Tome 89, N° S Le Syndicat National des Employés de la Compagnie Electrique du Saguenay (Formation).722 Monitor Publishing Company Limited (Directeurs).726 Montreal Skeet Club (Règlement).725 Radio Rouyn-Abitibi Ltée (Dist.de l'actif).721 Rideau Memorial Gardens Limited (Règlements) .721 The Pembroke Electric Light Company Limited (Barrage).723 The Shawinigan Water and Power Company (Directeurs).725 The Valley Shoe Company Incorporated (Directeurs).724 The West End Figure Skating Club Inc.(Règlements).722 Westwood Clothes Inc.(Directeurs).726 Chartes \u2014 Abandon de: Hochelaga Converters Limited.727 The Rouyn-Noranda Publishing Company Limited.727 Compagnies dissoutes: Adams Pharmacal Products (Que) Ltd.727 Garage St-Louis lue.727 (iilpin Insulation Quebec Limited.727 Harrogate Textiles Corp.728 Hide Fur & Skin Brokers Corp.728 Lyman Corporation.Limited.728 Wilwood Security Company.,.728 DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Affaires Municipales: Beauport, ville.729 Instruction publique: Municipalité scolaire de: Poularics (Erratum).729 Terres et Forets: Service du Cadastre: St-François-dc-Sales, paroisse.729 St-Joachim-de-Châteauguay, paroisse.730 St-Laurent, paroisse.730 Travail: Industrie ou métiers de: Concernant une convention collective relative à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.737 Construction, région de Rimouski (Modification).730 Robe, Province (Modification).0 731 Lettres patentes: Allied Equipment & Supply Inc.692 Bay Electric Company Ltd.693 Beatrice Pines Limited.693 Belga Inc.693 Cardinal Holdings Corp.694 - Central Bachelor Mines Corp.694 C.Fuoco Inc.694 Champ de Lys Café Inc.695 CM.& T.Contractors Ltd.695 Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée \u2014 Charlevoix Sa- Le Syndicat National des Employés de la Compagnie Electrique du Saguenay (Formation).'.722 Monitor Publishing Company Limited (Directors).726 Montreal Skeet Club (By-law).725 Radio Rouyn-Abitibi Ltée (Dist.of assets).721 Rideau Memorial Gardens Limited (Bylaws) .;.721 The Pembroke Electric Light Company Limited (Dam).723 The Shawinigan Water and Power Company (Directors).725 The Valley Shoe Company Incorporated (Directors).724 The West End Figure Skating Club Inc.(By-laws).722 Westwood Clothes Inc.(Directors).726 Charters \u2014 Surrender of: Hochelaga Converters L.mited.727 The Rouyn-Noranda Publishing Company Limited.727 Companies Dissolved: Adams Pharmacal Products (Que) Ltd.727 Garage St-Louis Inc.727 Gilpin Insulation Quebec Limited.727 Harrogate Textiles Corp.728 Hide Fur & Skin Brokers Corp.728 Lyman Corporation.Limited.728 Wilwood Security Company.728 DEPARTMENTAL NOTICES: Municipal Affairs: Beauport, town.729 Education: School Municipality of: Poularies (Erratum).729 Lands and Forest: Cadastral Branch: St-Francois-de-Sales, parish.729 St-Joachim-de-Châteauguay, parish- 730 St-Laurent, parish.730 Labour: Industry or Trades of: Concerning a collective agreement relating to the industry and trades of the construction in the region of Montreal.; 737 Construction, region of Rimouski, _ 1 (Amendment).730 Dress, Province (Amendment).731 Letters Patent: Allied Equipment & Supply Inc.692 Bay Electric Company Ltd.693 Beatrice Pines Limited.Belga Inc.Cardinal Holdings Corp.694 Central Bachelor Mines Corp.694 C.Fuoco Inc.5J{ Champ de Lys Café Inc.£95 CM.& T.Contractors Ltd.™ Compagnie de Navigation Charlevoix Saguenay Limitée \u2014 Charlevoix Sa- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 23rd, 1957, Vol.89, No.8 767 gucnay Navigation Company Limited .695 Converters Children's Wear Co.Ltd.696 D.& C.Electrie Ltée.696 Deacon Investment Corporation.697 Deshaies Automobiles Ltée.697 Desjardins Automobiles Inc.697 Desmarais & Frère Limitée.698 Drummond Auto Electric Ltée.698 Esker Quebec Mines Limited.698 Farman Investment Inc.699 Fibercut Appliances Limited.699 Fox Brothers Ltd.699 darage Idéal Incorporée.700 (ïarage Légaré & Frère Limitée.700 C rapide Industries Ltd.700 IL Blanchctte Ltée.701 Héroux & Fils Inc.701 Hôpital Général Fleury, Inc.701 Jacques Cartier Cie Inc.702 John Y.Stanfield Company Ltd.702 Joseph-Antoine Santerre Inc.702 .1.1».Nadeau Ltée.703 J.W.Cook Ltée.703 Kay Industries Inc.704 Keystone Realties (Que.) Ltd.704 Kyak Quebec Mines Limited .704 Lansdowne Corporation.705 La Plomberie Sicotte Ltée.705 La Société Montmorency Inc.705 Lenor Limitée.706 Les Ateliers Presto Inc.\u2014 Presto Motor Works Inc.706 Les Entreprises de L'Iserhoff Limitée \u2014 The Iserhoff Enterprises Limited 706 Les Entreprises Triange Inc.707 Les Voyages Organisés Inc.707 Lionel Bérubé Incorporé \u2014 Lionel Bérubé Incorporated.707 Macan Holdings Inc.708 Magasin Continental (St-Jérôme) Ltée \u2014 Continental Store (St.Jerome) Ltd.708 Marin Portraits Inc.708 Mel Simand Inc.709 National Cottons Ltd.709 National Metal & Smelters Inc.709 Nituk Quebec Mines Limited.710 Nuvilik Quebec Mines Limited.710 Petit Musée Limitée.711 Pripstein's Camp Inc.711 Propet Lie./.711 Raymor Company Ltd.\u2014 Compagnie Raymor Ltée.712 Renfrew Investment & Realties Co.712 Sano Wrap Towel Service Co.712 S.Beaulieu Furniture Inc.713 Shawinigan Mills Co.Ltd.713 Shop & Save (St.Adele) Ltd.713 Smolar Bros.Inc.714 Style Paint Company Limited.714 Sugluk Quebec Mines Limited.714 Taylaw ( 'orporation.715 Ungava Iron Ores Company.715 Vanasse Auto Inc.:.715 Veillet et Gosselin (Chibougamau) Limitée \u2014 Veillet and Gosselin (Chibougamau) Limited.716 Lettres patentes supplémentaires: A.B.C.Studios Inc.716 Aden Building Enterprises Inc.716 Copper Rand Chibougamau Mines Ltd.717 Dieter Hugo Stinnes Inc.717 Drew Brown Shipping and Trading Limited.717 Entrepôt Frigorifique Champlain Ltée guenay Navigation Company Limited .695 Converters Children's Wear Co.Ltd.696 D.& C.Electric Ltée.696 Deacon Investment Corporation.697 Deshaies Automobiles Ltée.697 Desjardins Automobiles lue.697 Dcsmarais & Frère Limitée.698 Drummond Auto Electric Ltée.698 Esker Quebec Mines Limited.698 Farman Investment Inc.699 Fibercut Appliances Limited.699 Fox Brothers Ltd.699 Garage Idéal Incorporée.700 Garage Légaré & Frère Limitée.700 Graphie Industries Ltd.700 IL Blanchette Ltée.701 Héroux & Fils Inc.701 Hôpital Général Fleury.Inc.701 Jacques Cartier Cie Inc.702 John Y.Stanfield Company Ltd.702 Joseph-Antoine Santerre lue.702 J.P.Nadeau Ltée.703 J.W.Cook Ltée.703 Kay Industries Inc.704 Keystone Realties (QueJ Ltd.704 Kyak Quebec Mines Limited.704 Lansdowne Corporation.705 La Plomberie Sicotte Ltée.705 La Société Montmorency Inc.705 Lenor Limitée.706 Les Ateliers Presto Inc.\u2014 Presto Motor Works Inc.706 tas Entreprises de L'Iserhoff Limitée \u2014 The Iserhoff Enterprises Limited.706 Les Entreprises Triange Inc.707 Les Voyages Organisés Inc.707 Lionel Bérubé Incorporé \u2014 Lionel Bérubé Incorporated.707 Macan Holdings Inc.708 Magasin Continental (St-Jérôme) Ltée \u2014 Continental Store (St.Jerome) Ltd.708 Marin Portraits Inc.708 Mel Simand Inc.709 National Cottons Ltd.709 National Metal & Smelters Ine.709 Nituk Quebec Mines Limited.710 Nuvilik Quebec Mines Limited.710 Petit Musée Limitée.711 Pripstcin's Camp Inc.711 Propet Inc.v 711 Raymor Company Ltd.\u2014 Compagnie Raymor Ltée.712 Renfrew Investment & Realties Co.712 Sano Wrap Towel Service Co.712 S.Beaulieu Furniture Inc.713 Shawinigan Mills Co.Ltd.713.Shop & Save (St.Adelc) Ltd.713 Smolar Bros.Inc.714 Style Paint Company Limited.714 Sugluk Quebec Mines Limited.714 Taylaw Corporat ion.715 Ungava Iron Ores Company.715 Vanassc Auto Inc.715 Veillet et Gosselin (Chibougamau) Limitée \u2014 Veillet and Gosselin (Chibougamau) Limited.716 Supplementary Letters Patent: A*.B.C.Studios Inc.716 Aden Building Enterprises Inc.716 Copper Rand Chibougamau Mines Ltd.717 Dieter Hugo Stinnes Inc.717 Drew Brown Shipping and Trading Limited.\u2022-\u2022\u2022 717 Entrepôt Frigorifique Champlain Ltée 768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 23 février 1957, Tome 89, N° S \u2014 Champlain Cold Storages Ltd.1.E.Lemieux Ltée.' Leeds Metals Company Ltd.Les Placements Gagnon Ltée.Rcdpath Realties Limited.Restaurant Ville-Marie Inc.Savanne Corporation.The Royal Montreal Golf Club-.Tremblay Lumber Co.Ltd.Truiror Securities Ltd.WM Doyle Limitée.Zenda Realties Limited.Ministère des Finances: Assurances: Citizens Insurance Company of New-Jersey (Annulation).North American Reinsurance Company (Nom changé).Nomination: Dumontier, Albert, juge des sessions.Sieges sociaux: Hart-Jaunc Power Company.H.Blanchette Ltée.Pal-Lick Investment Corporation.Quebec Cartier Mining Company.S.O.S.Taxi Ltée.Soumissions: Ste-Agathe-des-Monts, comm.scolaire.St-Laurcnt, comm.scolaire.Ste-Rose, comm.scolaire, ville.Ventes d'effets non-réclames:' Canadian Pacific Express Company.Canadian Pacific Railway Company.Vente, Loi de faillite: Villeneuve, Roland.Vente par licitation: Vineberg et al vs Vineberg.Ventes pour taxes: Chicoutimi, cité.Lac St-Jean-Est, munie., comté.Papineau.munie, comté (Erratum).VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi: Dufresne vs Lefcbvrc.Artiiabaska: Brouillard vs Coutu et al.Kamouraska: I^anglais vs Bélanger.Labelle: L'Office du Crédit agricole du Québec vs Larente.L'Office du Crédit Agricole du Québec vs Patry.717 \u2014Champlain Cold Storages Ltd____ 717 718 J.E.Lemieux Ltée.718 718 Leeds Metals Company Ltd.718 718 Les Placements (ïagnon Ltée.718 719 Rcdpath Realties Limited.719 719 Restaurant Ville-Marie Inc.719 719 Savanne Corporation.719 719 The Royal Montreal Golf Club.719 720 Tremblay Lumber Co.Ltd.720 720 Trumor Securities Ltd.720 720 WM Doyle Limitée.720 720 Zenda Realties Limited.720 Department of Finance: Insurance: Citizens Insurance Company of New- 748 Jersey (Cancellation).748 North American Reinsurance Company 747 (Name changed).717 Appointment: 748 Dumontier, Albert, judge of sessions.7-18 Head Offices: 749 Hart-Jaunc Power Company.719 748 IL Blanchctte Ltée.748 748 Pal-Lick Investment Corporation.748 749 Quebec Cartier Mining Company.719 749 S.O.S.Taxi Ltée.749 Tenders: 749 Ste-Agathe-des-Monts, school comm.749 751 St-Laurent, school comm.751 752 Ste-Rose, school comm., town.752 Sales of Unclaimed Baggage: 753 Canadian Pacific Express Company\u2014 753 753 Canadian Pacific Railway Company.753 Sale, Bankruptcy Act: 754 Villeneuve, Roland.754 Sale by Li citation: 754 Vineberg et al vs Vineberg.754 Sales for Taxes: 757 Chicoutimi, city.756 Lake St.John East, munie, county.756 758 Papineau.munie.,, county (Erratum).758 SHERIFFS' SALES: Abitibi: 758 Dufresne vs Lefebvrc.^58 Artiiabaska: 759 Brouillard vs Coutu et al.759 Kamouraska: 759 Langlais vs Bélanger.759 Labelle: Quebec Farm Credit Bureau vs Pat ry 760 760 Quebec Farm ('redit Bureau vs La- 760 rente.' QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February SSrd, 1957, Vol 89, No.8 769 Québec: \u2014Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer.Montmagny: Montmagny: La Caisse Populaire de St-Pierre-du-Sud La Caisse Populaire de St-Pierre-du- vsBlanchet.760 Sud vs Blanchet.760 Montréal: Montreal: Dagenais el al vs Héritiers de feu Ar- Dagenais et al vs Heirs to the late thur Tremblay.761 Arthur Tremblay.761 Myre vs Bastien.761 Myre vs Bastien.761 Nico .et: Nicolet: Boutin vs Aubin dit Mignault.762 Boutin vs Aubin said Mignault.762 Québec: Quebec: Beaulieu vs Giroux.762 Beaulieu vs Giroux.762 Roberval: Roberval: Dumais vs Lavoie.763 Dumais vs Lavoie.763 Léo Simard Ltée vs Juneau.764 Léo Simard Ltée vs Juneau.764 Saguenay: Saguenay: Les Pétroles Inc.vs Dufour.764 Les Pétroles Inc.vs Dufour.764 Saint-François: Saint Francis: Dubreuil vs Cloutier.765 Dubreuil vs Cloutier.765 44354-0 44354-0 \u2022 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.