Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 9 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1957-03-09, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tomb 89, N- 10 889 Vol.89, No.10 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officie! de la province (14 Ceo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC Qoébec, samedi 9 mars 1957 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues oflicielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Satubday, March 9th, 1957 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 890 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 26G lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.44037 \u2014 l-52-o Lettres patentes (P.G.10231-57) Barraute Forest Products Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize janvier 1957, constituant en corporation: Jacques Charbonneau, Roger Bélanger, comptables, et Huguette Turcotte, sténographe, tous trois de Val-d'Or, pour les objets suivants: Exploiter des forêts; exercer le commerce du bois et de ses sous-produits; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Barraute Forest Products Limited\", avec un capital total de 810,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Barraute, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant.44443-0 P.FRENETTE.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Tburs-day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, tlie ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parlies, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 2GG lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.44037 \u2014 l-52-o Letters Patent (A.G.10234-57) Barrnutc Forest Products Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the sixteenth day of January 1957, incorporating: Jacques Charbonneau, Roger Bélanger, accountants, and Huguette Turcotte, stenographer, all three of Val d'Or, for the following purposes: Carry out logging operations; deal in lumber and the by-products thereof; carry on lni3 as general building contractors, under the name of \"Barraute Forest Products Limited\", with a total capital stock of 810,000, divided into -100 shares of 8100 each.The head office of the company will he at Barraute.judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January 1957.P.FRENETTE \u2022II113 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 891 (P.G.14136-56) Bélair & Bélair Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1956, constituant en corporation: Maurice Riel, avocat, Clermont Vernietle, stagiaire, tous deux de LaPrairio, et Lorraine Séguin, secrétaire, fille majeure, célibataire, de Boucherville, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Bélair & bélair Inc.\".avec un capital total de 810,000.divisé en 3,600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en -100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Martin, comté de Laval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre 1950.Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(P.G.10169-57) Boucherville Developments Ltd.Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre décembre 1950, constituant en corporation: E.Michale Berger, Donald Kujan, tous deux avocats, Rhoda Cohen, Sandra Herman, toutes deux secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, Avrum Cohen, étudiant, et Abraham Kastner, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Boucherville Developments Ltd.\", avec un capital total de S100.000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 9,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre decern lire 1950.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44443 P.FRENEITE.(P.G.10093-57) Boulangerie Léonard Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1957, constituant en corporation: Marcel Cinq-Mars, Maurice Lacroix, tous deux avocats, de Noranda, et Pauline Lefebvre Pelletier, secrétaire, épouse séparée de biens de Louis-J.Pelletier, de Rouyn, pour les objets suivants: Faire affaires comme boulangers et pâtissiers, sous le nom de \"Boulangerie Léonard Ltée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 5,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda._ Daté tlu bureau du Procureur général, le quinze janvier 1957.Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 .P.FRENETTE.(A.G.14136-56) Bélair & Bélair Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the \u2022 twenty-eighth day fo December 1956, incorporating: Maurice Riel, advocate.Clermont Vermette, law clerk, both of LaPrairic, and Lorraine Séguin, secretary, fille majeure, unmarried, of Boucherville, for the following purposes: To carry on business as genera! building contractors; deal in building materials, under the name of \"Bélair & Bélair Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 3,600 preferred shares of a par value of 810 each and 100 common shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Saint Martin, county of Laval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December 1956.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G: 10169-57) Boucherville Developments Ltd.Notice is hereby given thatunder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of December, 1956, incorporating: E.Michael Berger, Donald Kujan, both Attorneys, Rhoda Cohen, Sandra Herman, both secretaries, spinsters, filles majeures et usants de leurs droits, Avrum Cohen, student, and Abraham Kastner, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of aland, construction and improvement company, under the name of \"Boucherville Developments Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 100 common shares of S100 each and into 9,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44443-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10093-57) Boulangerie Léonard Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1957, incorporating: Marcel Cinq-Mars, Maurice Lacroix, both advocates, of Noranda, and Pauline Lefebvre Pelletier, secretary, wife separated as to property of Louis-J.Pelletier, of Rouyn, for the following purposes: To carry on business as bakers and pastry-makers under the name of \"Boulangerie Léonard Ltée\", with a total capital stock of 850,000, divided into 5,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1957.P.FRENEITE, 44443 Acting Deputy Attorney General. 892 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 (P.G.10200-57) Boxill Dry wall Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit janvier 1957, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Sarah Miller, sténographe, tous deux de Montréal et Clarence Reuben Gross, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à poser des planches murales en plâtre et celui qui consiste à finir des murs A sec à l'intérieur de résidences et autres bâtisses, sous le nom de \"Boxill Drywall Inc.\", avec un capital total de 82,000, divisé en 200 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 11113 P.FRENETTE.(P.G.100S5-57) Brcmages Corona Inc.Avis est donné qu'en vertu do la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1957.constituant en corporation: Diane Robillard Laurin, ménagère, veuve remariée sous le régime de la séparation de biens, au docteur Charles-E.Laurin, Florian Laniel et Claude Laniel, gérants, tous de Verdun, poulies objets suivants: Fabriquer, embouteiller et exercer le commerce de liqueurs douces et.essences de toutes sortes, sous le nom de \"Breuvages Corona Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(P.G.1010-1-57) Clover Realties & Mortgages Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1957, constituant en corporation: Maurice Dubuc, courtier d'assurances, Paulette Dubuc, commerçante, épouse séparée de biens dudit Maurice Dubuc, et Jean-Paul Trudeau, entrepreneur général, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents d'immeubles et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Clover Realties & Mortgages Co.Ltd.\", avec un capital total de 8-10,000, divisé en 200 actions ordinaires de Si00 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1551, rue Jean Talon, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(A.G.10255-57) Roxill Drywall Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1957, incorporating: Samuel David Rudenko, advocate and Queen's Counsel, Sarah Miller, stenographer, both of Montreal, and Clarence Reuben Gross, advocate, of West-mount, for the following purposes: To carry on the business of erecting and finishing plaster board ami dry wall finishers to the interior of dwellings and other buildings, under the name of \"Boxill Drywall Inc.\".with a total capital stock of S2.000* divided into 200 shares of 810 each.The head office of the company will be at Moi it real, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January.1957.P.FRENETTL.44443-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10085-57) Breuvages Corona Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1957, incorporating: Diane Robillard Laurin, housekeeper, widow remained under the regime of separate as to properly, to doctor Charles E.Laurin, Florian Laniel and Claude Laniel, managers, all of Verdun, for the following purposes: To manufacture bottle and deal in soft drinks and essence of every nature and kind, under the name of \"Breuvages Corona Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 350 preferred shares of a par value of 8100 each and 500 common shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10104-57) Clover Realties & Mortgages Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1957, incorporating: .Maurice Dubuc, insurance broker, Paulette Dubuc, dealer, wife separate as to property of the said Maurice Dubuc, and Jean-Paul Trudeau, general contractor, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on as real estate agents and general building contractors, under the name of \"Clover Realties & Mortgages Co.Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will he at 1551.Jean Talon Street, East Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 893 (P.G.10112-57) Desbiens Meubles Ltée Avis est.donné qu'on vertu de lu première parlie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze janvier 1957, constituant en corporation: Paul Duchesne, marchand, Béatrice Gauthier, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Paul Duchesne, tous deux de Rivière-du-Moulin, Marcel Tremblay, marchand, et Lucette Laberge, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Marcel Trcm-lilay.de (hicoutimi, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles, coffres-forts, appareils de réfrigération et de chauffage, appareils électriques et leurs accessoires; exercer le commerce d'automobiles et autres moyens de transport, de pelles mécaniques, quincailleries, matériaux de construction, munitions, vivres et vêtements, sous le nom de \"Desbiens Meubles Ltée\", avec un capital total de $30,000, divisé en 300 actions de 8100 chacune.Lc-siègc social de la compagnie sera à Desbiens, district judiciaire de Koberval.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1957.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(P.G.10180-57) Doris Beauty Supply Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a élé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en dale du dix-sept janvier 1957, constituant en corporation: Luc Geoffroy, avocat, de Chambly, Robert Duludc, avocat, de Dorion.et Réjane Schmidt, secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de produits de beauté en général, sous le nom de \"Doris Beauty Supply Inc.\", avec un capital divisé en 800 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social\" de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1957.L'Assistant-procurcur général suppléant, III! !.P.FRENETTE.(P.G.14064-56) Edward Brian Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie .le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1957, constituant en corporation: Hymaii Solomon, de Ville Mont-Royal, Louis Feigenbaum, de St-Laurent et Perry Meyer, de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de textiles, articles vestimentaires et fournitures de toutes sortes; et celui de propriétés immobilières, sous le non» de \"Edward Brian Corporation\", avec avec un capital total de 8100.000, divisé en o.OOO actions ordinaires de S10 chacune et 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.l.e siège social de la compagnie sera à Montreal, district judiciaire de Montréal.(A.G.10112-57) Dcsbicns Meubles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date I be fifteenth day of January, 1957, incorporating: Paul Duchesne, merchant, Béatrice Gauthier, housewife, wife contractually separate as to property of the said Paul Duchesne, both of Rivière-du-Moulin, Marcel Tremblay, merchant, and Lucette Laberge, housewife, wife contractually separate as to property of the said Marcel Tremblay, of Chicou-limi.for the following purposes: To carry on the industry and operate a business dealing in furniture, safes, réfrigéra I ion and heating appliances, electrical appliances and their accessories; to operate a business dealing in automobiles and other means of transportation, mechanical shovels, hardware, building materials, munitions, foodstuffs and clothing, under the name of \"Desbiens Meubles Ltée\", with a total capital stock of 830,000, divided into 300 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Desbiens, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10180-57) Doris Beauty Supply Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date (lie seventeenth day of January.1957, incorporating: Luc Geoffroy, advocate, of Chambly, Robert Dulude, advocate, of Dorion, and Réjane Schmidt, secretary, of full age, of Verdun, for the following purposes: To carry on an industry and to deal in beauty products generally, under the name of \"Doris Beauty Supply Inc.\", with a capital stock divided into S00 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of Januarv, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14004-56) Edward Brian Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1957, incorporating: Hyman Solomon, of the town of Mount Royal.Louis Feigenbaum, of St.Laurent, and Perry Meyer, of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in textiles, wearing apparel and furnishings of every kind; to deal with immoveable property, under the name of \"Edward Brian Corporation\", with a total capital stock of 8100,000.divided into 5,000 common shares of 810 each and into 5.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 894 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 Daté «lu bureau du Procureur général, le neuf janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant.Ill 13 P.FRENEITE.(P.G.10009-57) Electro-Aslral's Co.Lid.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit janvier 1957, constituant en corporation: André Ferrebœuf, courtier d'immeuble, Fernand Garcia, vendeur, tous deux de .Montréal, et Maurice Hillion, agent d'immeuble, de Ville St-Michel, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'appareils de chauffage et appareils électriques, sous le nom de \"Electro-Astral's Co.Ltd.\", avec un capital total de S20.000, divisé en 200 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3443, rue Saint-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant.44443-0 P.FRENETTE.(P.G.14134-50) Electro Electric & Heating Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit janvier 1957, constituant en corporation: Irwin Glisernian, Mœ Ackman, tous deux avocats, de Montréal et Maurice Gold, comptable, de St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'électriciens; fabriquer et faire le commerce d'appareils électriques et de chauffage, sous le nom de \"Electro Electric & Heating Ltd.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443 P.FRENETTE.(P.G.10103-57) Fred's Tire Shop Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize janvier 1957.constituant en corporation: (îérard Beaupré, Marcel Trudeau, avocats, et Suzanne Laframboise, secrétaire, célibataire majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de pneus, chambres à air, accessoires et pièces pour voitures automobiles de toutes sortes; faire affaires comme garagistes, sous le nom «le \"Fred's Tire Shop Ltd.\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale.Le siège social de la compagnie sera à Pont-Viau, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General this ninth day of January, 1957.P.FRENETTE, 11113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10009-57) Electro-Astral's Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1957, incorporating: André Ferrcbœuf, real estate broker, Fernand Garcia, salesman, both of Montreal, and Maurice Billion, real estate agent, of the town of St.Michel, for the following purposes: To carry on a business dealing in healing and electrical apparatus, under the name of \"Electro-Astral's Co.Ltd.\", with a total capital stock of 820,000.divided into 200 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 3443 Saint-Denis Street, Montreal, judicial district of .Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1957.P.FRENETTE, 441-13 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14134-56) Electro Electric & Heating Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January.1957, incorporating: Irwin Glisernian.Mce Ackman, both advocates, of M out real, and Maurice Gold, accountant, for the following purposes: To carry on business as electricians; to manufacture ami deal in electrical and heating apparatus, under the name of \"Electro Electric & Heating Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10103-57) Fred's Tire Shop Ltd.Notice is hereby given that under Pari I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of January 1957, incorporating: Gérard Beaupré, Marcel Trudeau, advocates, and Suzanne La-framboise, secretary, unmarried and of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal in tires, inner tubes, automobile parts and accessories of every kind; carry on business as garage-keepers, under the name of \"Fred's Tire Shop Ltd.with a capital divided into 100 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Pont Viau, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting'.Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 895 (P.G.10283-57) Gcnlincau Inc.Avis est.donné qu'en vertu de la première parlic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois janvier 1957, constituant en corporation: J.-René Gauthier, Dollard Dansereau et J.-Gérard Hébert, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires connue entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Gcnlincau Inc.*', avec un capital total de 820.000.divisé en 200 actions communes de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5930, rue Saint-Hubert, Montréal, district, judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(P.G.11009-50) Ghislau Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 19Ô7.constituant en corporation: Dr.Roger IVrricr.chirurgien vétérinaire, Rolland Reeves, prospecteur et André Begin, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et minerais, et les négocier, sous le nom de \"Ghislau Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de $5,000,000.divisé en 5,000,000 d'actions d'une valeur au pair de 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à 5558, 5c Avenue, Rosemont, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, Il113 P.FRENETTE.(P.G.1000S-57) Hébert Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1957, constituant en corporation: Frédéric Hébert, Jean-Paul Langlois, tous deux notaires et Renaud Lagacé, agent d'assurances, tous trois de Noranda, pour les objets suivants: I ransiger les affaires d'une compagnie de portefeuille et de placements, sous le nom de Hébert Investments Ltd.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda._ Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44tl3 P.FRENETTE.(A.G.102S3-57) Gcnlincau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of January, 1957, incorporating: J.-René Gauthier.Dollard Dansereau and J.-Gérard Hébert, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors; to operate a business dealing in buildings materials, under the name of \"Gcnlincau Inc.\", with a total capital stock of 820,000, divided info 200 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at 5930 Saint-Hubert street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of January, 1957.P.FRENETTE, III13 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14099-56) Ghislau Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1957, incorporating: Dr.Roger Pcrrier, veterinary surgeon, Rolland Reeves, prospector, and André Begin, lawyer, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Ghislau Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 85,000,-000, divided into 5,000,000 shares of a par value of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head oflice of the company will be at 555S, 5th Avenue, Roscmount, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of Januarv, 1957.P.FRENETTE, 44443-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.1000S-57) Hébert Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1957, incorporating: Frédéric Hébert.Jean-Paul Langlois, both notaries, and Renaud Lagacé, insurance agent, all three of Noranda, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"Hébert Investments Ltd.\", with a total capital stock of S 10,000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company will be at Noranda, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443-0 Acting Deputy Attorney General. 896 GAZETTE OFFICIELLED E QUÉBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 (P.G.14116-56) Hôpital Général de Pointe aux Trembles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize janvier 1957, constituant en corporation: J.-Clovis Dagenais, avocat, Huguette Lavigueur, secrétaire, fille majeure, et Kcné Lcfcbvre, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Établir un hôpital général, sous le \"nom de \"Hôpital Général de Pointe aux Trembles Inc.\", avec un capital total de 810.900, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair de 8190 chacune.Le siège social de la compagnie sera 591, Bième avenue, Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant.44443-0 P.FRENETTE.(P.G.10048-57) J.L.Laccrtc & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cpiinze janvier 1957, constituant en corporation: J.-Lauda Laccrtc, Maurice Lacerte, tous deux entrepreneurs-plombiers, et Mme Onédà Beaulieu, ménagère, épouse séparée de biens dudit .L-Lauda Lacerte, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Grand'Mère, poulies objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage, et réfrigération exercer le commerce d'appareils et accessoires électriques, y compris l'entretien, sous le nom de \"J.L.Lacerte & Fils Ltée\", avec un capital total de 845.000, divisé en 450 actions communes de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grand'Mère, district judiciaire des Trois-Rivièrcs.Daté du bureau du Procureur général, le quinze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(P.G.10071-57) Juron Corporation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1957, constituant en corporation; Roy Fraser Elliot, avocat, de ville Mont-Royal, Mary Elizabeth Spracklin et Margot Mary Quinn, toutes deux secretaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Juron Corporation Limited\", avec un capital total de 81,500,000, divisé en 75,000 actions catégorie \"A\" d'une valeur au pair de SI chacune, 13,500 actions catégorie \"B\" d'une valeur au pair de 8100 chacune et 7,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2100 rue Delisle, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443 P.FRENETTE.(A.G.14116-56) Hôpital Général de Pointe aux Trembles lue.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of January.1957.incorporating: J.-Clovis Dagenais, advocate, Huguette Lavigueur, secretary, fille majeure, and René Lefebvrc, secretary, all of Montreal, for the following purposes: Establish a general hospital, under the name of \"Hôpital Général de Pointe aux Trembles Inc.\", with a total capital stock of 819.000, divided into 300 preferred shares of a par value of 8100 each and 100 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at 501 6th, Avenue, Pointe aux Trembles, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January.1957.P.FRENETTE, 111 13 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10048-57) J.L.Lacerte & Fils Liée Notice is hereby given that under Pari I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of January, 1957, incorporating: J.-Lauda Lacerte, Maurice Lacerte, both plumbing contractors, and Mrs.Onéda Beaulieu.housewife, wife separate as to property of the said J.Lauda Lacerte, and duly authorized by him for the purposes therein, all of Grand'Mère, for the following purposes: To carry on business as plumbing, heating and refrigerating contractors; deal in electrical apparatus and accessories, including the maintenance thereof, under the name of \"J.L.Lacerte & Fils Ltée\", with a total capital stock of $45,-000.divided into 450 common shares of $100 each.The head office of the company will he at Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of January, 1957.P.FRENETTE.11143 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10071-57) Juron Corporation Limited Notice is hereby given that under Pari I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January.1957, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, of the town of Mount Royal, Mary Elizabeth Spracklin and Margot Mary Quinn, both secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an invest ment and holding company, under the name of '¦Juron Corporation Limited\", with a total capital stock of 81,500,000, divided into 75,000 shares class \"A\" of a par value of $1 each and into 13,500 shares class \"B\" of a par value of 8100 each and into 7.500 common shares of a par value of »1U each.The bead office of the company will be a 2100, Delisle Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 897 (P.G.13SG2-5G) Labelle Textiles Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize janvier 1957, constituant en corporation: Milton Mendelsohn, marchand, Sheila Shuler Shutcr Mendelsohn, ménagère, épouse séparée ,1,.biens dudit Milton Mendelsohn, Joseph Mendelsohn, marchand, et Helen Itovitch Mendelsohn, ménagère épouse séparée de biens dudil Joseph Menselsohn, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises sèches, soies, satins, fournitures pour tailleur, tissus textiles, marchandises de drap et coton de toutes sortes, sous le nom de \"Labelle Textiles Co.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4-153 boulevard St-Laurcnt, Montréal, district judiciaire île Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le seize janvier 1957.L'Assistant-procureur général supputant.41 ! 13 P.FRENEITE.(P.G.misO-57) La Chambre de Commerce des Jeunes de Sainlc-Anne-de-la-Pérade Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu quatorze janvier: 1957 constituant en corporation sans capital-actions: Claude Biais, gérant de production, Jean-Marie Ct>ssette, hôtelier, Laurent Marchand, pilote.Paul Charest.notaire.Guy Guindon, courtier en assurances, Yvon Parent, agronome, Wilfrid Laganière, commis, et Jean Lacoùrsière, employé (l'industrie laitière, tous de Sainte-Anne-de-la-Pérade, pour les objets suivants: Travailler au progrès moral, intellectuel, culturel, économique, civique et social des membres «le celle corporation et de la population de la paroisse de Ste-Anne-de-Ja-Pérade, sous le nom de \"La Chambre de Commerce des Jeunes de Ste-Anne-de-la-Pérade Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers (pie la corporation peut posséder, est de $20.000.Le siège social de la corporation sera à Sainte-Anne-dc-la-Pérade, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENEITE.(A.G.138G2-5G) Labelle Textiles Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of January, 1957, incorporating: Milton Mendelsohn, merchant, Sheila Shutcr Mendelsohn, housewife, wife separate as to property of the said Milton Mendelsohn, Joseph Mendelsohn, mendiant, and Helen Itovitch Mendelsohn, housewife, wife separate as to property of the said Joseph Mendelsohn, all of Montreal, for the following purposes: To deal in dry goods, silks, satins, tailor's trimmings, textile fabrics, cloth and cotton goods of every kind, under the name of \"Labelle Textiles Co.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 4453, St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of January, 1957.P.FRENETTE, 44443-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.1018G-57) La Chambre de Commerce des Jeunes de Sainte-Anne-dc-la-Pérade Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing 7 les règlements Nos 1 à 10 inclusivement de Max Seigler\u2014Bert Siverman Foundation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 28c jour de février 1957.Le Sous-secrétaire de la province, 44452 JE AN BRUCHÉSI.(P.G.12429-55) Mr.Vernon Corp.Règlement N° 22 \"Sur proposition dûment exposée et secondé, il a été résolu: Qu'un règlement devant être connu comme le règlement N° 22 de la compagnie, soit et il est décrété comme suit: Que le nombre de directeurs de la compagnie soit augmenté de trois à cinq directeurs\".Vraie copie certifiée du règlement N° 22 tel qu'adopté parle bureau de direction et approuvé par les actionnaires le 9 mai 1956.Le Secrétaire, 44456 BEN CARON.(P.G.13105-56) Avmor Chidougamau Mines Limited (No Personal Liability) Règlement N° 72 augmentant le nombre des directeurs de trois à cinq.Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de cinq directeurs dont trois formeront quorum a toute assemblée du bureau de direction.Décrété à une assemblée des directeurs tenue le 14 janvier 1957, et ratifié par tous les actionnaires présents à une assemblée spéciale tenue le même jour.Le Secrétaire, 444Ô7-0 A.COHEN, Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Le Club Social des Travailleurs Inc.Avis est donné que lors d'une assemblée des actionnaires de \"Le Club Social des Travailleurs Inc.\".tenue le 30 octobre 1956 à Québec, une resolution a été adopté en vue d'autoriser la compagnie à distribuer son actif parmi ses actionnaires et subséquemment procéder à sa dissolution en abandonnant sa charte suivant l'ar- Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Pouplaire de St-Louis-de-Montfort\" under date February 18, 1957, whereof the head office is at Pont-Viau, county of Laval, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-sixth day of February, 1957.JEAN BRUCHÉSI, 44451 Under Secretary of the Province.(A.G.13477-56) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-laws Nos 1 to 10 inclusive of Max Seigler \u2014 Bert Siverman Foundation have been approved on February 27th, 1957,' by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of February.1957.JEAN BRUCHÉSI, 44452-o Under Secretary of the Province.m \u2014 (A.G.12429-55) Mt.Vernon Corp.By-laxo No.22 \"Upon motion duly made and seconded, it was unanimously resloved: That a by-law, to be known as By-law No.22 of the company, be and it is enacted as follows: That the number of directors of the company be increased from three to five directors.\" Certified tru copy of By-law No.22, as adopted by the board of directors and approved by the shareholders on May 9th, 1956.Secretary, 44456-0 BEN CARON.(A.G.13105-56) Avmor Chibougamau Mines Limited (No Personal Liability) By-law No.72 increasing the number of directors from three to five.The affairs of the company shall be managed by a board of five directors, three of whom shall form quorum at any meeting of the board.Enacted by the directors on January 14th, 1957, and ratified by all the shareholders present at a special meeting held on the same day.A.COHEN, 44457-o Secretary.Canada \u2014 Province of Quebec District of Quebec Le Club Social des Travailleurs Inc.Notice is given that at a meeting of shareholders of \"Le Club Social des Travailleurs Inc.\", held October 30, 1956 at Quebec, a resolution was adopted for the purposes of authorizing the company to distribute its assets among its shareholders and proceed subsequently with its dissolution by surrendering its charter according to 910 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 ticle vingt-six (26) de la Loi des compagnies de Québec.Québec, le 25 février 1957.Le Président, JOSEPH MATTE.Le Secrétaire, 44458-0 LUCIEN DEBLOIS.(P.G.12404-54) Virginia Mining Corporation (No Personal Liability) Règlement N° S3 qui augmente le nombre de directeurs de la compagnie \"Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété comme le règlement N 23 de la compagnie, ce qui suit: Le nombre de directeurs de la compagnie est, par les présentes, augmenté de neuf à onze.\" Décrété par le bureau de direction de Virginia Mining Corporation (No Personal Liability), le 2e jour de novembre 1956, et approuvé, ratifié et confirmé par les actionnaires le 19e jour de novembre 1956.Le Secrétaire, 44459 S.J.SMILEY.(P.G.10564-57) S.M.Koury & Fils Limitée S.M.Koury & Sons Limited Règlement N° A \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme règlement de \"S.M.Koury & Fils Limitée \u2014 S.M.Koury & Sons Limited\", que la situation du siège social de la compagnie soit et elle est, par les présentes, changée de Ste-Agathe des Monts, district de Terrebonne, à 2917 nie Masson, en les cité et district de Montréal, province de Québec.Nous, les soussignés, Salim Koury et Mischcll Koury, président et secrétaire respectivement de \"S.M.Koury & Fils Limitée \u2014 S.M.Koury & Sons Limited\", certifions, par lçs présentes, sous le sceau corporatif de la compagnie, que le précédent est une copie authentique et conforme du règlement N° A de la compagnie adopté régulièrement par le bureau de direction de ladite compagnie à une assemblée dûment et régulièrement convoquée et tenue au bureau de la compagnie le 21e jour de décembre 1956, le tojit des manière et formule requises par la Loi; et qu'à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie dûment et régulièrement convoquée et tenue au bureau de la compagnie le 21e jour de décembre 1956, ledit règlement N° A a été dûment ratifié, confirmé et approuvé pour fins légales; et qu'à ladite assemblée générale spéciale des actionnaires, les actionnaires présents détenaient tout le capital-actions de la compagnie; et que les actionnaires qui votèrent en faveur du-dit règlement détenaient tout le capital-actions émis et réparti de la compagnie.Et nous avons signé à Montréal, ce 21e jour de décembre 1956.(Sceau) Le Présdient, S.M.KOURY.section twenty-six (26) of the\\juebcc Companies' Act.Quebec, February 25, 1957.Joseph math:.President.LUCIEN DEBLOIS.44458 Secretary.(a.G.12404-54) Virginia Mining Corporation (No Personal Liability) By-law No.28 increasing the number of directors of the company \"Be it and it is hereby enacted as by-law Xo.23 of the company , as follows: The number of directors of the company is hereby increased from nine to eleven\".Enacted by the board of directors of Virginia Mining Corporation (No Personal Liability) on the 2nd day of November 1956, ami approved, ratified and confirmed by the shareholders on the 19th day of November, 1956.s.J.SMILEY, 44459-0 Secretary.(A.G.10564-57) s.M.Koury & Fils Limitée s.M.Koury & Sons Limited By-law No.A \"Be it enacted and it herebv enacted as a by-law of \"s.M.Koury & Fils Limitée S.M.Koury & Sons Limited\" that the location of the head office of the company be and the same is hereby changed from Ste.Agathe des Monts, district of Terrebonne, to 2917 Masson Sheet in the city and district of Montreal, in the Province of Quebec.\" We, the undersigned.Salim Koury and Mis-chell Koury, respectively president and secretary of \"s.M.Koury & Fils Limitée \u2014s.M.Koury & Sons Limited\" do hereby certify under the corporate seal of the company that the foregoing is a true and correct copy of by-law No.A of the company regularly adopted by the board of directors of the said company at a meeting duly and regularly called and held at the office of the company on the 21st day of December, 1956, the wholfpp.the manner and form by law required; and that at a special general Meeting of the shareholders of the company duly and regularly called-and held at the office of the company on the 21st day of December, 1956, the said bylaw NO.A was duly ratified, confirmed and approved for all legal purposes; and that al the said special general meeting of shareholders, the shareholders present held themselves all the issued capital stock of the company; and that the shareholders wdio voted in favour of the said by-law held themselves all the issued and allotted capital stock of the company.And we have signed at Montreal, this 21st day of December, 1956.(Seal) s.M.KOUBY, President.44461 Le Secrétaire, MISCHELL koury, MISCHELL KOURY.4446l-o Secretary, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 911 (p.G.10564-57) S.M.Kourv & Fils Limitée S.M.Koury & Sons Limited Règlement N° B \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété connue un règlement de S.M.Koury & Fils Limitée \u2014 S.M.Koury & Sons Limited, que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à cinq, de manière que le bureau de direction de la compagnie soit et sera dorénavant formé de cinq directeurs.Trois directeurs constitueront quorum à toute assemblée du bureau de direction.Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui, sont par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.\" Nous, les soussignés, Salim Koury et Mischcll Koury, président et secrétaire, respectivement de S.M.Koury & Fils Limitée \u2014 S.M.Koury Si Sous Limited, certifions, par les présentes, sous le sceau corporatif de la compagnie, que le précédent est une copie authentique et conforme du règlement N° B de la compagnie adopté régulièrement par le bureau de direction de ladite compagnie à une assemblée dûment et régulièrement convoquée et tenue au bureau de la compagnie le 21e jour de décembre 1950, le tout des manière et formule requises par la Loi et qu'à une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie dûment et régulièrement convoquée et tenue au bureau de la compagnie le 21e jour de décembre 1950, ledit règlement B a été dûment ratifié, confirmé et approuvé pour fins légales; et qu'à ladite assemblée générale spéciale des actionnaires, les actionnaires présents détenaient tout le capital-actions de la compagnie; et que les actionnaires qui votèrent en faveur dudit règlement détenaient tout le capital-actions émis et réparti de la compagnie.El nous avons signé à Montréal, ce 21e jour de décembre 1950.'Sceau) Le Président, S.M.KOURY.Le Secrétaire, 44461 MISCHELL KOURY.Avis de rachat partiel Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Ville LaSalle (Comté de Jacques-Cartier) Émission de SI,230,000.00 à 3-3%%, portant la date du 1er mai 1955 et échéant en séries jusqu'au 1er mai 1975 (résolutions d'emprunt en date du 7 février, 1955, 4 avril 1955 et 4 avril 1955).Avis public est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de \\ illc LaSalle, comté de Jacques-Cartier, rachèteront par anticipation, au pair, le 1er mai 1957, en vertu d'une clause de rachat insérée dans lesdites résolutions d'emprunt, et reproduite sur les obligations, les obligations suivantes: 31 x S 1.009.00 Nos M-11S0, 1181, 1182, 1183, Il M.1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192.1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204.1205, 1206, 1207, 120S.1209 et 1210 de l'année 1975 à 3%%.Lesdites obligations deviendront dues et payables et elles seront payables et rachetées, principal et intérêt, à la date ci-dessus mentionnée, en monnaie légale du Canada, avec intérêt (A.G.10561-57) S.M.Koury & Fild Limitée S.M.Koury & Sons Limited By-law No.B \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of S.M.Koury & Fils Limitée \u2014 S.M.Koury & Sons Limited, that the number of directors of the company be and the same are hereby increased from three to five, so that the board of directors of the company be and it shall hereafter be composed of five directors.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.All prior, by-laws resolution and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this present by-law\".We, the undersigned, Salim Koury and Mischcll Koury, respectively president and secretary of S.M.Koury & Fils Limitée \u2014 S.AI.Koury & Sons Limited do hereby certify under the corporate seal of the company that the foregoing is a true and correct copy of by-law No.B of the company regularly adopted by the board of directors of the said company at a meeting duly and regularly called and held at the office of the company on the 21st day of December, 1956.the whole in the manner and form by law required; and that at a special general meeting of the shareholders of the company duly and regularly called and held at the office of the company on the 21st day of December, 1956, the said by-law No.B was duly ratified, confirmed a1 d approved for all legal purposes; and that at the said special .general meeting of shareholders, the shareholders present held themselves all the issued capital stock of the company; and that the shareholders who voted in favour of the s'iid by-law held themselves all the issued and allotted capital stock of the company.And we have signed at Montre d, this 21st day of December, 1956.(Seal) S.M.KOURY, President.MISCHELL KOURY.44161-0 Secretary.* Notice of partial redemption The School Commission for the Municipality of the town of LaSalle (County of Jacques-Cartier) Issue of bonds for Si,230,000.00 at 3-3%%, bearing date of May 1st, 1955, and maturing serially up to May 1st, 1975 (loan resolutions dated February 7, 1955, April 4, 1955 and April 4, 1955).Public notice is hereby given that the school commissioners for the municipality of the town of LaSalle, county of Jacques-Cartier, will redeem in advance, at par, on May 1st, 1957, in accordance with.a redemption clause inserted in the said loan resolutions, and reproduced on the bonds, the following bonds: 31 x 81,000.00 Nos.M-11S0, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199.1200, 1201, 1202, 1203.1204, 1205, 1206.1207, 1208, 1209 and 1210 of th year 1975 at 3%%.The said bonds shall become due and payable and shall be payable and redeemed, principal and interest, on the above mentioned date, in legal ¦Canadian currency, with accrued interest up 912 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 couru jusqu'au 1er mai 1957, sur présentation et remise d'iccllcs, avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 1er mai 1957 attachés, à toutes les succursales de la Banque Canadienne Nationale dans la province de Québec, ainsi qu'à la succursale de ladite banque à Toronto, au choix du détenteur.Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er mai 1957.Donné à Ville LaSalle, comté de Jacques-Cartier, ce 2 mars 1957.Le Secrétaire-trésorier.44464-o ALBERT GRAVEL.to May 1st, 1957 upon presentation and surrender of same, together with all interest coupons maturing after May 1st, 1957 attached thereto, at all the branches of the Canadian National Hank in the Province of Quebec, as well as at the branch of the said bank at Toronto, according to tlio option of the holder.The said bonds shall cease to bear interest as from May 1st, 1957.Given at the town of LaSalle, county of Jacques-Cartier, this 2nd day of March, 1957.ALBERT GRAVE I,.44464 Secretary-Treasurer.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de St-Étiennc de Montréal\", en date du 20 février 1957, dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-huit février 1957.Le Sous-sccrétairc de la province, 4447l-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné par les soussignés que le Lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, en date du 27 février 1957, un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom de la \"Municipalité du canton de Whitton\" en celui de \"Municipalité de Nantes\", comté de Frontenac.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Springhill, 2 mars 1957.Le Maire, ALPHONSE JULIEN.Le Sécrétai re-tréosorier, 44474-Q J.A.BAILLARGEON.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats profcssionnles, S.R.Q., 1941, chapitre 102, telles qu'ajoutées par la Loi II George VI, chapitre 52, article 5, l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le vingt-huit février 1957, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Le Syndicat C.N.des Employés de Commerce de Victoriaville\", dont la formation avait été autorisée le 9 décembre 1952, avec siège social à Victoriaville, comté d'Arthabaska.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le cinq mars 1957.Le Sous-sccrétairc de la province.44443-0 .TEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndical.' \"La Caisse Populaire de St-Êtienne de Mon!réal*', under date of February 20, 1957, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-eighth day of February 1957.JEAN BRUCHÉSI.44471 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted on February 27.1957, an Order in Council to the effect of changing the name of \"Municipality of the township of Whitton\" into that of \".Municipality of Nantes\", county of Frontenac.Pursuant to the provisions of article is of the Municipal Code, this change of name enters into force from and after the publication of the present notice in the Quebec Official Gazette.Springhill, March 2, 1957.ALPHONSE JULIEN.Mayor.J.A.BAILLARGEON.44474 Secretary-Treasurer.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added (hereto by Act II, George VI, chapter 52, section 5, the Honourable the Provincial Secretary, has enacted under date of February twenty-eighth 1957, the termination of the corporate existence of the Professional Syndicate \"Le Syndicat ('.N- des Employés de Commerce de Victoriaville\", the formation of which had been authorized December 9, 1952, with head office at Victoriaville, county of Arthabaska.Given at the office of the Provincial Secretary, the fifth day of March, 1957.JEAN BRUCHESI, 44443 Under Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné par les soussignés que le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, en date du 27 février 1957 un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom de la municipalité du village de Wickham-Ouest en celui de \"Municipalité du village de Wickham\", comté de Drummond.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council ha* adopted, on February 27, 1957, an Order m Council to the effect of changing the name of the municipality of the village of Wickham-Wea into that of \"Municipality of the village « Wickham\", county of Drummond.Pursuant to the provisions of section IS of the Municipal Code, this change of name enters into QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89.No.10 913 entre à vigueur à compter de la piddication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Wickham Ouest, le 5 mars 1957.Le Maire.LORENZO MARTIN.Le Secrétaire-trésorier, 44488-0 LUCIEN LEMOYNE.Corporation des Ingénieurs forestiers de la province de quédec Avis Les personnes qui pratiquent le génie forestier dans la province de Québec contrairement aux dispositions de la Loi concernant la Corporation des Ingénieurs forestiers de la province de Québec (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 273; 13 George VI, chapitre 06; 4-5 Elizabeth II, chapitre 64), seront sujettes, à compter du 1er mars 1958.aux sanctions prévues par les dispositions de ladite Loi.Le Secrétaire, ¦MISO-o THÉO MERCIER.Bills, Assemblée législative force from and after the publication of the present notice in the Quebec Official Gazette.Wickham-West, March 5, 1957.LORENZO MARTIN, Mayor.LUCIEN LEMOYNE, 44488 Secretary-Treasurer.Corporation of Forest Engineers of the Province of Quebec Notice Persons practising forest engineering in the Province of Quebec contrary to the provisions of the law concerning the Corporation of Forest Engineers of the Province of Quebec (Revised Statutes of Quebec, 1911, chapter 273; 13 George VI, chapter 66; 4-5 Elizabeth II, chapter 64), will, from the 1st March 1958, be subject to the penalties prescribed in the said law.THÉO MERCIER, 44486-o Secretary.Bills, Legislative Assembly Chambre du Conseil législatif Québec, 21 février 1957.Aujourd'hui, à quatre heures et quarante-cinq minutes de l'après-midi, l'honorable lieutenant-gouverneur s'est rendu à la chambre du Conseil législatif, au Palais législatif.Les membres du Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur d'y faire requérir la présence de l'Assemblée législative et, cette chambre s'y étant rendue, le greffier de la couronne en chancellerie a lu les titres des bills à être sanctionnés comme suit: 37 Loi autorisant la construction d'une autoroute Montréal-Laurentides.39 Loi modifiant la Loi électorale de Québec.40 Loi concernant l'assistance aux mères né- cessiteuses et la Commission des allocations sociales de Québec.42 Loi concernant le développement minier et la location d'une partie des forces hydrauliques sur la rivière Hart-Jaune.44 Loi modifiant la Loi concernant les corporations et compagnies.46 Loi modifiant la Loi concernant les valeurs mobilières.4< Loi concernant les inspecteurs des bureaux d'enregistrement.48 Loi modifiant la Loi des cites et villes.49 Loi concernant les membres de la Legisla- ture.« 50 Loi concernant l'Hôpital Saint-Michel Ar- change.Legislative Council Chamber Quebec, 21st of February, 1957.This day, at four o'clock and forty-five minutes in the afternoon, the Honourable theu Lie-tenant-Governo prroceeded to the Legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and, that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 37 An Act to authorize the construction of a Montrcal-Laurentian Autoroute.39 An Act to amend the Quebec Election Act.40 An Act respecting assistance to needy mothers and the Quebec Social Allowances Commission.42 An Act respecting the mining development and the leasing of part of the water-powers on the Hart-Jaune river.44 An Act to amend the Act respecting corporations and companies.40 An Act to amend the Quebec Securities Act.47 An Act respecting inspectors of registry offices.48 An Act to amend the Cities and Towns Act.49 An Act respecting the members of, the Legislature.50 An Act respecting l'Hôpital Saint-Michel Archange. 914 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 51 Loi concernant la Loi des produits laitiers.52 Loi modifiant la Loi des véhicules automo- biles.53 Loi modifiant la Loi de la Régie des trans- ports.54 Loi modifiant la Loi des mines de Québec.55 Loi concernant la municipalité du village de Sutton, dans le comté de Brome.56 Loi concernant la preuve photographique de certains documents.57 Loi modifiant la Loi de l'exécutif et concer- nant le greffier du Conseil exécutif.58 Loi facilitant davantage .l'exécution d'un projet d'élimination de taudis et de construction de logements salubres dans la cité de Montréal.59 Loi concernant l'Hôpital Notre-Dame.60 Loi modifiant la Loi des syndicats coopé- ratifs de Québec.61 Loi modifiant le Code de procédure civile.62 Loi pour faciliter le développement minier et industriel dans le Nouveau-Québec et concernant.Oceanic Iron Ore (Quebec) Limited.63 Loi pour faciliter le développement minier et industriel dans le Nouveau-Québec et concernant Atlantic Iron Ores Limited.64 Loi facilitant les communications entre les comtés de Saguenay et de Charlevoix.65 Loi concernant la vente et la distribution du gaz et la Régie provinciale de l'électricité.66 Loi modifiant le Code civil.67 Loi relative à la Commission des écoles catholiques de Québec.68 Loi relative à la distribution du gaz naturel dans la cité et la région métropolitaine de Montréal.95 Loi concernant la ville d'Acton Vale.104 Loi modifiant la charte de la ville de Don-nacona et concernant les corporations municipales de Cap-Santé et de Les Écureuils, ainsi que Les commissaires d'écoles pour les municipalités de Donna-cona, de Cap-Santé et de Les Écureuils, dans le comté de Portncuf.136 Loi concernant Samuel Solnik De Abra- vanel.137 Loi concernant certains droits civils des ¦ enfants de Hector L.Godin.140 Loi concernant la succession de feu Thomas F.Davidson.51 An Act respecting the Dairy Products Act.52 An Act to amend the Motor Vehicles Act.53 An Act to amend the Transportation Hoard Act.54 An Act to amend the Quebec Mining Act.55 An Act respecting the municipality of the village of Sutton, in the county of Brome.56 An Act respecting photographic proof of certain documents.57 An Act to amend the Executive Power Act and respecting the Clerk of the Executive Council.58 An Act further to facilitate the carrying out of a plan for the elimination of slums and the construction of sanitary dwellings in the city of Montreal.59 An Act respecting Notre-Dame Hospital.60 An Act to amend the Quebec Cooperative Syndicates Act.61 An Act to amend the Code of Civil Proce- dure.% 62 An Act to facilitate mining and industrial development in New Quebec and respecting Oceanic Iron Ore (Quebec) Limited.63 An Act to facilitate mining and industrial development in New Quebec and respecting Atlantic Iron Ores Limited.64 An- Act to facilitate communications be- tween the counties of Saguenay and of Charlevoix.65 An Act respecting the sale and distribution of gas and the Provincial Electricity Board.66 An Act to amend the Civil Code.67 An Act respecting The Catholic School Commission of Quebec.6S An Act respecting the distribution of natural gas in the city and the metropolitan area of Montreal.95 An Act respecting the town of Acton Vale.104 An Act to amend the charter of the town of Donnacona and respecting the municipal corporations of Cap-Santé and Les Écureuils as well as The school commissioners for the municipalities of Donnacona, Cap-Santé and Les Écureuils, in the county of Portncuf.136 An Act respecting Samuel Solnik De Aura- vanel.137 An Act respecting certain civil rights of the children of Hector L.Godin.» 140 An Act respecting the estate of the late Thomas F.Davidson. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol 89, No.10 915 145 Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Greenfield Park et modifiant sa charte.150 Loi accordant certains pouvoirs à la corporation municipale de la paroisse Sainte-Anne de Varennes.153 Loi annexant une partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Lachenaie et une partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne à la ville de Terrebonne.154 Loi modifiant la charte de la ville de Sept- Hcs.164 Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Laurent.167 Loi refondant la charte de la cité de Lévis.168 Loi modifiant la loi 15 George V, chapitre 45, concernant les écoles protestantes dans la cité de Montréal et ses environs.171 Loi modifiant la charte de la cité de Dorval.177 Loi modifiant la charte de la ville de Rivière des Prairies.ISO Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Vincent-de-Paul.181 Loi modifiant la charte de la ville de La Tuque.182 Loi modifiant la charte de la ville de Tracy.IcSô Loi constituant la corporatiori de l'École des hautes études commerciales de Montréal.107 Loi validant et confirmant le titre d'Albini Carrière à la propriété d'une terre formée de partie du lot numéro 105, au cadastre de la paroisse de Boucherville, et de partie du lot numéro 258 au cadastre de la paroisse de Varennes.202 Loi modifiant la charte de la cité de Lachine.203 Loi constituant en corporation la ville de Fabreville.205 Loi modifiant la charte de la cité de Longueuil.210 Loi modifiant la charte de la cité de Beau-harnois.213 fxu modifiant la charte de la cité de Sauite-Foy.217 Loi modifiant la charte de la ville de Baie Comeau.219 Loi modifiant la charte de la cité de Québec.223 Loi concernant la charte de la ville Laval des Rapides., .226 Loi modifiant Ja charte de la ville de Beauce-ville-Est.145 An Act to grant certain powers to the town of Greenfield Park and to amend its charter.150 An Act to grant certain powers to the municipal corporation of the parish of Sainte-Anne de Varennes.153 An Act to annex a part of the territory of the municipality of the parish of Lachenaie and part of the municipality of the parish of Saint-Louis de Terrebonne to the town of Terrebonne.154 An Act to amend the charter of the town of Sept-Res.164 An Act to amend the charter of the city of Saint-Laurent.167 An Act to consolidate the charter of the city of Levis.168 An Act to amend the act 15 George V, chapter 45, respecting Protestant schools in and around the city of Montreal.171 An Act to amend the charter of the city of Dorval.177 An Act to amend the charter of the town of Rivière des Prairies.180 An Act to amen the chaown rtehtdertf o of Saint-Vincent-de-Paul.181 An Act to amend the charter of the town of La Tuque.182 An Act to amend the charter of the town of Tracy.185 An Act to incorporate the École des hautes études commerciales de Montréal.197 An Act to validate and confirm the title of Albini Carrière to the ownership of parcel a of land composed of part of lot number 195 of the official cadastre for the parish of Boucherville and of part of lot number 258 of the official cadastre for the parish of Varennes.292 An Act to amend the charter of the city of Lachine.203 An Act to incorporate the town of Fabreville.205 An Act to amend the charter of the city of Longueuil.210 An Act to amend the charter of the city of Beauharnois.213 An Act to amend the charter of the city of Sainte-Foy.217 An Act to amend the charter of the town of Baie Comeau.219 An Act to amend the charter of the city of Quebec.223 An Act respecting the charter of the town of Laval des Rapides.226 An Act to amend the charter of the town of East Beauceville. 916 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 236 Loi modifiant la charte de la cite de Sorel.239 Loi concernant la Commission des écoles catholiques de Montréal.240 Loi modifiant la charte de la ville de Laval Ouest.241 Loi refondant la charte de l'Industrielle Compagnie d'Assurance sur la Vie.244 Loi modifiant la charte de la cité de Sher- brooke.245 Loi modifiant la charte de la ville de Gati- neau et concernant La commission scolaire catholique Saint-Jean Vianney de Gatineau.247 Loi concernant le testament de feu Ernest B.Décaric et ratifiant le titre de dame Sophia Paleologos, veuve de John Pcr-gantis alias Demetre a un certain immeuble.248 Loi concernant Les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Saint-Félicien.249 Loi modifiant la charte de la cité des Trois- Rivières.251 Loi constituant en corporation de ville la municipalité du village de Delson et y annexant certaines parties de territoire et annexant aussi une certaine partie de territoire à La commission scolaire de Delson.252 Loi autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre Henry Ballon Nevard à l'exercice de la profession d'avocat dans la province de Québec.253 Loi concernant la succession de feu Charles Raymond.254 Loi concernant la ville de La Prairie.255 Loi modifiant la Loi concernant la Com- mission des écoles catholiques des Trois-Rivières.256 Loi exemptant de taxes municipales et sco- laires les immeubles employés dans la cité de Grand'Mère, pour fins de recherches scientifiques.La sanction royale est prononcée sur ces.bills par le greffier du Conseil législatif comme suit: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 30 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1958, et pour d'autres fuis.A ce bill la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses loyaux sujets, accepte leur bénévolence et sanctionne ce bill.\" 44484-0 236 An Act to amend the charter of the city of Sorel.239 An Act respecting the Montreal Catholic School Commission.240 An Act to amend the charter of the town of Laval West.241 An Act to consolidate the charter of Indus- trial Life Insurance Company.244 An Act to amend the charter of the city of Sherbrooke.245 An Act to amend the charter of the town of Gatineau and respecting The Catholic school commission of Saint-Jean Vianncy dc Gatineau.247 An Act.respecting the will of the late Ernest B.Décaric and to ratify the title of Dame Sophia Paleologos, widow of John Pergantis alias Demctrc to a certain immoveable.248 An Act respecting The school commis- sioners for the municipality of the village of Saint-Félicien.249 An Act to amend the charter of the city of Trois-Rivières.251 An Act to incorporate as a town the mu- nicipality of the village of Delson and to annex thereto certain portions of territory and also to annex a certain portion of territory to The school bo rd of Delson.252 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit Henry Ballon Nevard to the practice of the legal profession in the Province of Quebec.253 An Act respecting the estate of the late Charles Raymond.254 An Act respecting the town of La Prairie.255 An Act to amend the Act respecting the Three Rivers Catholic School Commission.256 An Act to exempt from municipal and school taxes the immoveables used, in the city of Grand'Mère for purposes of scientific research.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council, in the following words: \"In her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 30 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March, 1958, and for other purposes.To this bill the Royal assent was signified in the following words: \"In#Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor thanks Her loyal subjects* accepts their benevolence and assents to this bill- 44 1S4-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE ,Quebcc, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 917 Chartes \u2014 Abandon de Avis est donné que Show Mart Investment Con.oration \u2014 La Corporation du Palais du Commerce, une compagnie constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de M lut réal, demandera au Procureur Général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies «le Québec.I laté à Montréal, le 28 février 19ô7.(Sceau) Show Mart Investment Corporation La Corporation du Palais du Commerce.Le Secrétaire, 44447-0 ANDRÉ CHARRON.Avis est par les présentes donné que \"Autobus Régional Limitée\", dûment constituée en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, chapitre 270 S.R.Q.Québec 1951, et ayant son siège social à Trois-Pistoles, P.Q., s'adressera au Procureur Général de la province de Québec, pour permission d'abandonner sa chart e.en vertu des dispositions de la loi des Compagnies de Québec, articles 26 et 27 de ladite loi.Daté à Trois-Pistoles, P.Q.le 27 février 1957.Le Secrétaire-trésorier, 44472-0 CHARLEMAGNE CÔTÉ.AVIS Prenez avis (pie la compagnie \"Quebec Mining Explorers Limited (Libre de responsabilité personnelle)\" demandera au Procureur général la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 2 mars 1957.Les Procureurs de la Compagnie, 44473-0 PINARD & PINARD.St.Alexander Parking Coup.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"St.Alexander Parking Corp.\", constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispo lions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 28c jour de février 1957.Le Procureur «le St.Alexander Parking Corp.MONROE ABBEY.GGOou.-t.rue Ste-Catherine, Suite 604, -Montréal, Que.44485 Compagnies dissoutes (P.C.10030-50) Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par Charters \u2014 Surrender of Notice is hereby given that Show Mart Investment Corporation \u2014¦ La Corporation du Palais «lu Commerce, a corporation constituted under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the city of Montreal will apply to the Attorney-General for the province of Quebec for leave to surrender its Charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 28th dav of Februarv, 1957.(Seal) Show Mart Investment Corporation La Corporation du Palais «lu Commerce ANDRÉ CHARRON, 44447-0 Secretary.Notice is hereby given that \"Autobus Régional Limitée\", duly constituted under the Quebec Companies' Act, chapter 276 R.S.Q.1951, and having its head office in Trois-Pistoles, P.Q., will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act, sections 26 and 27 of the said Act.Date«l at Trois-Pistoles, this 27th of February, 1957.CHARLEMAGNE CÔTÉ, 44472-0 Secretary-Treasurer.NOTICE Please take notice that the company, \"Quebec Mining Explorers Limited (Free of personal liability)\" will apply to the General Attorney for leave to surrender its charter and its cancellation after such date as he may deem fit to determine.Montreal, March 2, 1957.PINARD & PINARD, 44473-0 Attorneys of the Company.St.Alexander Parking Corp.Notice is hereby given that \"St.Alexander Parking Corp.\", incorporated uiuler the Quebec Companies' Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter, under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 28th day of February, 1957.MONROE ABBEY, Attorney for St.Alexander Parking Corp.660 St.Catherine St.West, Suite 604, Montreal, Que.44485-o Companies Dissolved (A.G.10630-50) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the At- 918 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"Central Business College Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes en «late du 17 juillet 1934.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant.44443-0 P.FRENETTE.(P.G.14010-56) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \" Collmar Trading Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 avril 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENEITE.(P.G.12659-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Diamond Coal Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 avril 1924.Avis est de plus donné qu'à compter «lu vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENEITE.(P.G.11820-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de la«lite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"Gresham Investments Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 novembre 1953.Avis est de plus donné qu'à compter «lu vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENEITE.(P.G.12983-56) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de \"La Compagnie des Immeubles Viger Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 août 1948.torney General, ahs been pleased to accept thè surrender of the charter of the company \"Out ml Business College Incorporated\", incorporated by letters patent dated July 17, 1934.Notice is also given that from and after February twenty-eighth, 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attornev General this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14010-50) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Collmar Trading Co.Ltd.\", incorporated bv letters patent dated April 9, 1948.Notice is also given that from and after February twenty-eighth, 1957, the said company has been dissolved.Date«l at the office of the Attorney General, this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12659-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Diamond Coal Limited\", incorporated by letters patent dated April 26, 1924.Notice is also given that from and after February twenty-eighth, 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of March, 1957.P.FRENEITE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11820-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, an«l subject to the liability enacted by section 27 of the sai«l Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Gresham Investments Inc.\", indorporatcd by letters patent dated November 4, 1953.Notice is also given that from and after February twenty-eighth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of March, 1957.P.FRENEITE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12983-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"La Compagnie des Immeubles Viger Limitée\", incorporated by letters patent dated August 11, 1948. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol.89, No.10 919 Avis est de pins donné qu'à compter du vingt- Notice is also given that from and after Fe-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute, bruary twenty-eighth 1957, the said company has been dissoved.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1957.I,'Assistant-procureur général suppléant, 111 l3-o P.FRENEITE.(P.G.13759-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1911, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Mark Craft Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 avril 1951.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.(P.G.12055-56) Avis est donné qu'en vertu de la première parlie de la Loi des compagnies de Québec, Statut s refondus de Québec, 1911, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Topex Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 16 juillet 1930.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 4443-0 P.FRENETTE.(P.G.12834-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"United Traders Corp'n Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 janvier 1947.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-huit lévrier 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-0 P.FRENETTE.Dated at the office of the Arttonev General, this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13759-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enactetl by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Mark Craft Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated April 26, 1954.Notice is also given that from and after February twenty-eighth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12055-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, ami subject, to the liability enacte«l by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Topex Limited.\", incorporated by letters patent dated July 16, 1930.Notice is also given that from and after February twenty-eighth 1957, the said company has been dissolved.Date«l at the office of the Attorney General, this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12834-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, ahs been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"United Traders Corp'n Ltd.\", incorporated by letters patent dated January 25, 1947.Notice is also given that from and after February twenty-eigyth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first tlay of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12211-56) Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 276, (A.G.12211-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Walsh compagnie \"Walsh Adhesives Corp.\", constituée Adhesives Corp.\", incorporated by letters patent «lated October 22, 1954.article 20.et sujet, à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la on corporation par lettres patentes en date du 22 octobre 1954.Avis est de plus «lonné qu'à compter «lu vingt-huit février 1957.ladite compagnie a été dissoute, Daté du bureau «lu Procureur général, le premier mars 1957.b Assistant -procureur général suppléant, ^-o p.FRENETTE.Notice is also given that from and after February twenty-eighth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General. 920 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 mars 1957, Tome 89, N° 10 (P.G.10020-50) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Wilfrid Arehambault Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 avril 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-huit février 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44443-Q P.FRENETTE.(A.G.10020-5G) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Wilfrid Arehambault Limitée\", incorporated by letters patent dated April 22.1948.Notice is also given that from and after February twenty-eighth, 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of March, 1957.P.FRENETTE, 44443 Acting Deputy Attorney General.Département de l'Instruction Publique N° 1373-56.Québec, le 26 février 1957.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Ras de la Petite Côte Stc-Rose, dans le comté de Laval, à celui de la municipalité scolaire de Haut de la Petite Côte Stc-Rose, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44428-9-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1303-50.Québec, le 26 février 1957.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Rury, dans le comté de Compton, les lots 34 à 41 inclusivement des rangs X et XI du canton de Bury, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Ste-Marguerite-de-Lingwick, môme comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44429-9-2-o O.-J.DESAULNIERS.N° 491-52.Québec, le 4 mars 1957.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 27 février 1957, d'annexer aux municipalités scolaires de St-Édouard-dc-Knowlton, et St-André-dc-Sutton, dans le comte de Brome, le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Henri-dc-Brôme, même comté, pour les contribuables catholiques seulement, comme ci-dessous metnionné: 1° Le territoire qui serait annexé à la municipalité scolaire de St-Edouard-de-Knowlton est décrit comme suit: les lots primitifs suivants, tous inclusivement du canton de Brome, 1 à 15 du rang IV; 1 à 20 des rangs V, VI et VII et le tiers sud du lot 21 de ce dernier rang portant les nos de subdivisions 828, 829; 1 à 7 du rang VIII et 1 à G des rangs IX, X et XL 2° Le territoire qui serait annexé à la municipalité scolaire de St-André-de-Sutton comprend les lots 21 à 28 inclusivement des rangs X et XI du canton de Sutton.Cet.arrêté ministériel prendra effet au 1er juillet 1957.Le Surintendant de l'Instruction publique.44462-o O.J.DÊSAULNLERS.N° 542-55.Quebec, le 5 mars 1957.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 27 février 1957, Department of Education No.1373-56) Quebec, February 26, 1957.Application is made to annex the present territory of the school municipality of \"Bas de la Petite Côte Ste-Rose\", in the county of Laval, to that of the school municipality of \"Haut de la Petite Côte Ste-Rose\", same county.O.J.DESAULNIERS, 44428-9-2 Superintendent of Education.No.1303-56) Quebec, February 26, 1957.Application is made to detach from the school municipality of Bury, in the county of Compton, lots 34 to 41 inclusively of ranges X and XI of the township of Bury, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of Ste-Marguerite-de-Lingwick, same county.0.J.DESAULNIERS.44429-9-2 Superintendent of Education.No.491-52.Quebec, March 4, 1957.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated February 27, 1957, has been pleased to annex to the shcool municipalities of St.Edouard-de-Knowlton.and St.André-de-Sutton, in the county of Brome, the present territory of the school municipality of St-Hcnri-de-Brôme, same county, for Catholic ratepayers only, as hcreinunder mentioned: 1.The territory to be annexed to the School Municipality of St.Edduard-de-Khowlton is described as follows: the following original lots, all inclusive of the Township of Brome, 1 to 15, Range IV; 1 to 20, Ranges V, VI and VII and the southerly third of lot 21 of the latter Range, bearing subdivision numbers 828 and 829; 1 to 7, Range VIII and 1 to 6 of Ranges IX, X and XL 2.The territory to be annexed to the School Municipality of St.André-de-Sutton comprises lots 21 to 28 inclusive, of Ranges X and XI of the Township of Sutton.This Order in Council will take effect on July 1st, 1957.O.J.DESAULNIERS.44462 Superintendent of Education.No.542-55.Quebec, March 5, 1957.t His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated February 2,, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 9th, 1957, Vol 89, Nol 10 921 de détacher de la municipalité scolaire de St-Damase, dans le comté de St-IIyacinthe, le territoire ci-dessous décrit et de l'annexer à la municipalité scolaire de St-Jcan-Baptiste, dans le comté de Rouville.Ce territoire comprend, en référence au cadastre officiel de la paroisse St-Jean-Baptiste, oiuté de Rouville, les lots 461, 575, 577, 579, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 590, 593, 594, 597, 598, 599, 095, 696 et 697.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1957.Le Surintendant de l'Instruction publique.44462-0 O.J.DESAULNIERS.N° 111-57.Québec, le 5 mars 1957.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 27 février 1957, de changer le nom de la municipalité scolaire de Wickham-Ouest, dans le comté de Drummond, en celui de \"La municipalité scolaire de Wickham, dans le comté de Drummond.\" Ce changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle ce Québec.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44462-0 O.J.DESAULNIERS.1957, has been pleased to detach from the school municipality of St-Damase, in the county of St.Hyacinthe, the territory hereinbelow described and to annex it to the school municipality of St.Jean-Baptiste, in the county of Rouville.This territory is comprised, with reference to the official cadastre of the parish of St.Jean-Baptiste, county of Rouville, lots 461, 575, 577, 579, 582, 5S3, 584, 586, 587, 588, 590; 593, 594, 597, 598, 599, 095, 696, 697.This change will take effect on July 1st, 1957.O.J.DESAULNIERS, 44462 Superintendent of Education.No.111-57.Quebec, March 5, 1957.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated February 27, 1957, has been pleased to change the name of the school municipality of Wickham-West, in the county of Drummond, into that of \"The School Municipality of Wickham, in the county of Drummond\".This change in Council will take effect eight days after the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.O.J.DESAULNIERS, 44462 Superintendent of Education.N° 169-49.Québec, le 5 mars 1957.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel numéro 193 en date du 27 février 1957, d'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"La municipalité scolaire de la ville de Haie Comeau, dans le comte de Saguenay\" le territoire attribué à cette dite ville par le chapitre 120 de la loi I George VI (1937) et ses amendements, territoire qui n'est pas encore organiser au point de vue scolaire.Ce changement; prendra effet quinze jours après la date de cet arrêté ministériel.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44462-0 O.J.DESAULNIERS.N° 43-57.Québec, le 5 mars 1957.H a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel numéro 193 en date du 27 février 1957, de changer le nom de la municipalité] scolaire de Petit Lac Magog, dans le comté de Sherbrooke, en celui de \"La municipalité Molaire de Village de Deauville, dans le comté de Sherbrooke\".Ce changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44462-0 O.J.DESAULNIERS.N° 234-38.Québec, le 5 mars 1957.H a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel numéro 193, en date du 27 février 1957, d'annexer à la municipalité scolaire de Rapide Danseur, dans le comté d'A-hitibi-Oucst, les lots 47 à 62 inclusivement des rangs VIII et IX du canton Duparquct, territoire non-organisé au point de vue scolaire.Ce changement prendra effet quinze jours après la date de cet arrêté ministériel.Le Surintendnat de l'Instruction publique, 44462-
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.