Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 mai 1958, samedi 3 (no 18)
[" Tome 90, N° 18 1637 /p (A.G.10710-58) Hubert Piché Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1958, incorporating: Hubert Piché, electrician, Jean-Paul Léonard, notary, and Louise Faubert, secretary, spinster of full 1642 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 bataire majeure, tous de Saint-Jérôme, pour les objets suivants: Faire a.Taires comme électriciens; exercer l'industrie et le commerce d'appareils et d'accessoires électriques, sous le nom de \"Hubert Piché Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé On 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 cahcune.Le siège social de la compagnie sera 595, avenue Parent, Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, .47956-0 1 P.FRENETTE.(P.G.10171-58) * Jagal Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première 'partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Emmanuel Cooke, d'Outremont, Joseph H.Freedman, de Montréal, tous deux avocats et Morris Galet, marchand, de St-Laurent, pour tes objets suivants: Transiger les affaires d'une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de '\"Jagal Realties Inc.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.11018-58) \\ Jean Julien Fortin & Compagnie Limitée 1 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la 'province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: Jean-Julien For'in.ing.p., ingénieur-conseil.Pearl Tremblay Fortin, sténographe, majeure» épouse séparée de biens dudit Jean-Julien 'Fortin, et dûment autorisée par lui, et Bertrand Gagnon, dessinateur, majeur, tous de Chicoutimi, pour les objets suivaEts: Exercer l'industrie et le commerce de matériaux de construction et de machineries, sous le nom de \"Jean Julien Fortin & Compagnie Limitée\", avec un capital fo'al de $100,000, divisé 'en 10,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 582.boulevard Lamarche, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958., L'Assistant-procureur général suppléant.47656-0 P.FRENETTE.(P.G.10586V58) Kingston Wire Products (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1958, constituant en corporation: John Rudinsky, de Ville Mont-Roval, Harold Haines de la cité de New York, de l'Etat age, all of Saint-Jérôme, for the following purposes: - To carry on business as electricians; to operate and industry and business dealing in electrical apparatus and accessories, under the name of \"Hubert Piché Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 595 Parent Avenue, Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.\u2022 P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10171-58) Jagal Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958,- incorporating: Emmanuel Cooke, of Outremont, Joseph H.Freedman, of Montreal, both advocates, and Morris Galet, merchant, of St.Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment corporation, under the name of \"Jagal Realties Inc.\", with a total capital stock of $40,000, Rivided into 1,000 common shares of $1 each and into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE.47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11018-58) Jean Julien Fortin & Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the \"Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: Jean-Julien For' in, prof, engineer, consulting engineer, Pearl Tremblay Fortin, stenographer, of full age, wife separate as to property of the said Jean-Julien Fortin, and duly authorized by him, and Bertrand Gagnon, draftsman, of full age, all of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the industry and business dealing in building materials and in machinery, under the name of \".Jean Julien Fortin & Compagnie Limitée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 582 Lamarche Boulevard, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10586-58) Kingston Wire Products (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1958, incorporating: John Rudinsky, of the town of Mount Royal, Harold Haines, of the city of New York, State of New QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1643 de New York, E.U.A., tous deux fabricants, et Samuel R.Altrows, avocat, de Montréal pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce et le négoce de toutes sortes de métaux et produits d'iceux, sous le nom de \"Kingston Wire Products (Canada) Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 50 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10243-58) Lachine Plate Glass Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Lucien Jolicoeur, peintre, de Lachine, Armand Poupart, fils, avocat, et Monique Duquette, sténographe, célibataire majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et comme décorateurs, peintres et quincailliers, sous le nom de \"Lachine Plate Glass Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.s Le siège social de la compagnie sera à Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656-0 P.FRENETTE.(P.G.10628-58) Le Village Steakhouse & Delicatessen Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Max S.Kaufman, de Westmount, J.Roy Ho.T-man, de Montréal, Oscar Respitz, de Ville Mont-Royal, tous trois avocats et Iris New, secrétaire, fille majeure, de Montréal pour les objets suivants: Exploiter un \"steakhouse\" et un restaurant de charcuterie accompagnée des services connexes, sous le nom de \"Le Village Steakhouse & Delicatessen Ltd.\",.avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.11020-58) Marché Paradis Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: Paul-André Paradis, Jean-Marc Paradis, York, United States of America, both manufacturers, and Samuel R.Altrows, advocate, of Montreal, for the following purposes: To manufacture, deal and trade in all kinds of metals and metal products, under the name of \"Kingston Wire Products (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 50 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10243-58) Lachine Plate Glass Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Lucien Jolicoeur, painter, of Lachine, Armand Poupart, son, advocate, and Monique Duquette, stenographer, spinster of full age, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors in construction and as decorators, painters and hardware dealers, under the name of \"Lachine Plate Glass Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 900 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.' P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10628-58) Le Village Steakhouse & Delicatessen Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Max S.Kaufman, of Westmount, J.Roy HoTman, of Montreal, Oscar Respitz, of the town of Mont Royal, all three advocates, and Iris New, secretary, of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To operate a steakhouse and delicatessen restaurant with accessory services, under the name of \"Le Village Steakhouse & Delicatessen Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11020-58) Marché Paradis Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patsnTTmve, ^v.^ been issued by the Lieutenant-Goveft^w the ^Â Province of Quebec, bearing dato-.tfte twenty- ,_ first day of March 1958, incorp£retinjtflKaU& Fabriquer et exercer le commerce d'articles tricotés, vêtements et textiles, sous le nom de \"Pride O'GIen Knitting Mills of Canada Limited\", avec un capital total de 140,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10516-58) Québec Steak House Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: André-S.Bertrand, restaurateur, Yolande Carrier, gérante, célibataire, tous deux de Québec, et Jean-Marie Paquet, comptable, de Château-d'Eau, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Québec Steak House Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 600 actions de $100 chacune.Le sirge social de la compagnie sera 465, rue de la Couronne, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656-o P.FRENETTE.(P.G.10887-58) Redmat Investment Corporation Avis e?t dorme qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dorze mare 1958, constituant en corporation: Max Slapatk, Gregory Charlap, Arthur Shulman, avocats, et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Redmat Investment Corporation\", avec un capital total de $100,000, divisé en 800 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.\u2022 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mare 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10892-58) Shopsy's Foods (Québec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mare 1958, constituant en corporation: Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1958, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross, Maurice Boxer, all three advocates, and Sarah Miller, stenographer, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitted goods, wearing apparel and textiles, under the name of \"Pride O'GIen Knitting Mills of Canada Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10516-58) Québec Steak House Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March 1958, incorporating: André-S.Bertrand, restaurateur, Yolande Carrier, manager, spinster, both of Quebec, and Jean-Marie Paquet, accountant, of Château d'Eau, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers and restaurateurs, under the name of \"Québec Steak House Inc.\", with a total capital stock of $60.000, divided into 600 shares of $100 each.The head office of the company will be at 465 de la Couronne Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March 1958.P.FRENETTE.47656 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10887-58) Redmat Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-gouvernor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of March, 1958, incorporating: Max S la pack, Gregory Charlap, Arthur Shulman, advocates, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster of the full age of mjajority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Redmat Investment Corporation\", with a total capital stock of $100,000, divided into 800 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10892-58) Shopsy's Foods (Québec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Ernest Wil- 1646 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N* 18 Ernest William Mockridge, gérant, de St-Lam-bert, Clifford George Meek, comptable, et Guy Ambrose Miller, teneur de livres, de Montréal, pour les objets suivants: Préparer et faire le commerce de produits alimentaires, sous le nom de \"Shopsy's Foods (Québec) Limited\", avec un capital total de $20,-000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10867-58) v Soda Bar (Montréal West) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mars 1958, constituant en corporation: Reuben Booke Cohen, fabricant, Dame Gertrude Cohen, ménagère, épouse contractuelle-ment séparée de biens de Louis Samuel Cohen, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, et Louis Samuel Cohen, gérant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"Sodar Bar (Montréal West) Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divise en 200 actions ordinaires de $50 chacune et 6,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal Ouest, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10630-58) Solco Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958.constituant en corporation: Elie Solomon, Gerald Cooper, notaires, et Marvin Riback, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, < sous le nom de \"Solco Investment Corporation\", avec un capital total de $40.-000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.a Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10.397-58) Soudure Atomic Welding Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1958, constituant en corporation: Roger Vandal, industriel, Maurice Rousseau, avocat, tous deux de St-Hyacinthé, et Roland liam Mockridge, manager, of St.Lambert, Clifford George Meek, accountant, and Guy Ambrose Miller, bookkeeper, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in food products, under the name of \"Shopsy's Foods (Québec) Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and into 10,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.¦ P.FRENETTE, 47656-0 Acting Deputy Attorney Genreal.(A.G.10867-58) Soda Bar (Montréal West) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth, day of March, 1958, incorporating: Reuben Booke Cohen, manufacturer.Dame Gertrude Cohen, housewife, wife contractually separate as to property of Louis Samuel Cohen, and duly authorized by him for these presents, and Louis Samuel Cohen, manager, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"Sodar Bar (Montréal West) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $50 each and into 6,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal West, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10630-58) Solco Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Elie Solomon, Gerald Cooper, notaries, and Marvin Riback, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Solco Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney \"General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10397-58) Soudure Atomic Welding Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the.Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: Roger Vandal, industrialist, Maurice Rousseau, advocate, both of St.Hyacinthe, and Roland Lehoux, industria- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1647 Lehoux, industriel, de village Casavant, pour les, objets suivants: Faire affaires comme ouvriers en métaux et exercer le commerce de machines, outils, instruments et moteurs, sous le nom de \"Soudure Atomic Welding Company Limited\" avec un capital total de $30,000, divisé en 2,000 actions communes de $10 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la paroisse de Douville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656-0 P.FRENETTE.list, of the village of Casavant, for the following purposes: To carry on business as metal workers and deal in machinery, tools, instruments and engines, under the name of \"Soudure Atomic Welding Company Limited\" with a total capital stock of $30,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be in the Parish of Douville, judicial district of Saint Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10950-58) St.Mark Cleaners Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mars 1958, constituant en corporation: Gabriel William Haltrecht, tailleur, Edith Haltrecht, ménagère, épouse séparée de biens dudit Gabriel William Haltrecht et Max Haltrecht, gérant de magasin, tous de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre le commerce qui consiste à confectionner, réparer, nettoyer, teindre et fournir des services divers, sous le nom de \"St.Mark Cleaners Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.> Le siège social de la*compagnie sera à Montréal, district' judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(A.G.10950-58) St.Mark Cleaners Inc.Notice is hereby given that under Part I of.the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1958, incorporating: Gabriel William Haltrecht, tailor, Edith Haltrecht, housewife wife separate as to property of the said Gabriel William Haltrecht, and Maxc Haltrecht, store manager, all of Montreal, for the following purposes: To engage in the business of tailoring, repairing, cleaning, dyeing and sundry services, under the name of \"St.Mark Cleaners Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of March.1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10938-58) Term-Oil Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro\\ine de Québec des lettres patentes, en date du quinze mars 1*958, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg.Irwin S.Brodie.avocats et Sonya Schneyer, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction: négocier des propriétés immobilières, sous le nom de \"Term-Oil Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $45,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacuue.Le si'ge social de la compagnie sera à 5111 rue de Salaberry, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(A.G.10938-58) Term-Oil Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fif'eenth day of March, 1958, incorporating: Cyril E.Schwisberg, Irwin S.Brodie, advocates, and Sonya Schneyer, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction company; to deal in immoveable properties, under the name of \"Term-Oil Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $45,000, divided into 150 common shares of $100 each and into 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 5111 de Salaberry Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney Geneial.(P.G.14148-57) Tcx-Knit Co.of Canada, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, avocat et conseil en loi de la Reine, Dame Rona Bloom et Dame Mary Watt, (A.G.14148-57) Tcx-Knit Co.of Canada, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, Dame Rona Bloom and Dame Mary Watt, secretaries, 1648 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de bourrures de planches à repasser, housses de planches à repasser, bourrures de matelas, bourrures en coton et produits textiles; négocier des propriétés immobilières, sous le nom de \"Tex-Knit Co.of Canada, Inc.\", avec un capital total de $75,-000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 6,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10886-58) Tower Distributors Ltd* Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec ces lettres patentes, en date du douze mars 1958, constituant en corporation: Gregory Charlap, Arthur Shulman, avocats, et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de marchandises sèches, textiles, coutellerie, quincaillerie, fournitures de maison, meubles, marchandises de cuir, bibelots, meanus articles, nouveautés, marchandises de sport, articles vestimentaires, chaussures, articles de fumeurs, nécessaires de toilette, cameras, accessoires de photographie, dispositifs et outillage motorisés, sous le nom de \"Tower Distributors Ltd.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10916-58) Treaver Properties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1958, constituant en corporation: Kenneth Simpson, Howard, avocat, Clifford George Meek, Guy Ambrose Miller, teneur de livres, tous trois de Montréal, Ernest William Mockridge, gérant, de St-Lambert, et Cecil Bruce Cooke, secrétaire, de Ste-Anne de Belle vue, pour les objtes suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, immeubles, construction et développement en général, sous le nom de \"Treaver Properties Limited\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ironing board pads, ironing board covers, mattress pads, cotton pads and textile products; to deal in immoveable properties, under the name of \"Tex-Knit Co.of Canada, Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 6,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General» this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10886-58) Tower Distributors Ltd.Notice is hereby given that under Part I* of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of March, 1958, incorporating: Gregory Charlap, Arthur Shulman, advocates, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, textiles, cutlery, hardware, household furnishings, furniture, leather goods, notions, smallwares, novelties, sporting goods, wearing apparel, footwear, smoking sundries, toilet articles, cameras and photographic supplies, automotive accessories and equipment, under the name of \"Tower Distributors Ltd.\", with a total capital stock of $30.000, divided into 2,000 common sabres of $10 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10916-58) Treaver Properties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first .day of March, 1958, incorportaing: Kenneth Simpson Howard, advocate, Clifford George Meek, Guy Ambrose Miller, bookkeepers, all three of Montreal, Ernest William Mockridge, manager, of St.Lambert, and Cecil Bruce Cooke, Secretary, of St.Anne-de-Bellevue, for the following purposes: To carry on the business of a land, real estate, construction and general development company, under the name of \"Treaver Properties Limited\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this flirty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1649 (P.G.10572-58) Unican Plastics (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: John J.Gotlieb, avocat et Conseil en Loi de la Reine, William I, Miller, avocat, David Finestone, comptable agréé, et Barnet Buck-man, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de substances Ç'astiques et chimiques, sous le nom de\"llnican lastics (Canada) Ltd.\", avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 P.FRENETTE.(P.G.10304-58) Vend -Master Corporation of Canada Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1958, constituant en corporation: Samuel Hertz Sliriar, avocat, de St-Laurent, Mollie Schwartz Fidelia Séguin, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de lessiveuses et de machines automatiques exploitées au moyen de pièces de monnaie, sous le nom de \"Vend-Master Corporation of Canada\", avec un capital total de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656 _ P.FRENETTE.(P.G.10837-58) Vinet Parking Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, Theodore H.Polisuk, Cyril E.Schwisberg, tous trois avocats, Anne Zifkin, et Sonya Schneyer, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires de garagistes, sous le nom de \"Vinet Parking Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1010 ouest, rue Ste-Catherine, suite 340, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.47656 _ P.FRENETTE.(P.G.10678-58) Zenith Offset Plates Inc.(A.G.10572-58) Unican Plastics (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: John J.Gotlieb, advocate and Queen's Counsel, William I.Miller, advocate, David Finestone, chartered accountant, and Barnet Buckman, notary, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in plastic or chemical substances, under the name of \"Unican Plastics (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General (A.G.10304-58) Vend-Master Corporation of Canada Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1958, incorporating: Samuel Hertz Shriar, advocate, of St.Laurent, Mollie Schwartz and Fidelia Séguin, secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automatic coin operated washing and vending machines, under the name of \"Vend-Master Corporation of Canada\", with a total capital stock of $50,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-0 Acting Deputy Attorney GeneraL (A.G.10837-58) ~~ Vinet Parking Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958, incorportaing: Samuel Greenblatt, Theodore H.Polisuk.Cyril E.Schwisberg, all three advocates, Anne Zifkin and Sonya Schneyer, secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage keepers, under the name of \"Vinet Parking Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 1010 St.Catherine Street, West, Suite 340, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10678-58) Zenith Offset Plates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby |pven that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the 1660 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1968,- constituant en corporation: André Surprenant, de Montréal, Bernard Nantel, de Westmount et Maurice Mercure, de V:lle Mont-Royal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de lithographes, imprimeurs et éditeurs, sous le nom de \"Zenith Offset Plates Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions privilégiées de $100 chacune et 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le si'ge social de la compagnie sera à 360 ouest, rue Craig, Montréal, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 47666 P.FRENETTE.Lettres patentes supplémentaires ¦ i ¦ - (P.G.10674-58) Bijouterie La Riviera Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du treize mars 1958, à la compagnie \"J.P.Larivière Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première Eartie de la Loi des compagnies de Québec, par ittres patentes du 20 février 1958, changeant son nom en celui de \"Bijouterie La Riviera Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le treize mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656-0 P.FRENETTE.(P.G.10672-58) Nouveautés du Meuble Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du treize mars 1958, à la compagnie \"J.A.Simoneau Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 20 février 1958, changeant son nom en celui de \"Nouveautés du Meuble Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le treize mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 475Ô5-0 P.FRENETTE.Arrêtés en Conseil ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 386 Section \"A\" Québec, le 24 avril 1958.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant des modifications au décret relatif à la fabrication des boites de carton gaufré dans la province.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts re- Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1968, incorporating: André Surprenant, of Montreal, Bernard Nantel, of West-mount, and Maurice Mercure, of the town of Mount Royal, all Lawyers, for the following purposes: To carry on business generally as lithographers, printers and publishers, under the name of \"Zenith Offset Plates Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 preferred shares of $100 each and into 300 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 360 Craig Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47656-o Acting Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent (A.G.10674-58) Bijouterie La Riviera Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Procince of Quebec, dated the thirteenth day of March 1968, to the company \"J.P.Larivière Limitée\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 20, 1958.changing its name to that of \"Bijouterie La Riviera Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of March 1958._ P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10672-58) Nouveautés du Meuble Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated March thirteenth, 1958, to the company \"J.A.Simoneau Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of February 20, 1958, changing is name into that of \"Nouveautés du Meuble Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of March, 1958._ .P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 386 Port \"i4\" Quebec, April 24,1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments of the decree relating relating to the manufacturing of corrugated paper boxes in the province.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1651 fondus de Québec 1041, chapitre 163 et amende- Quebec 1941, chapter 163 and amendments), ments), deux requêtes ont été présentées au two petitions have been presented to the Minis- Ministre du Travail à l'effet de soumettre à l'ap- ter of Labour begging him to submit to the con- prédation et à la décision du Lieutenant-Gou- sideration and decision of the Lieutenant-Gov- verneur en Conseil certaines modifications au ernor in Council some amendments to the décret numéro 728 du -6 juillet 19557 amendé decree number 728 of July 6, 1955, amended by Ear les arrêtés en conseil numéro 694-E du 4 juil- - Orders in Council numbers 694-E of July 4, 1956 t 1956 et 270-D du 21 mars 1957, relatif à la and 270-D of March 21, 1957, relating to the fabrication des bottes de carton gaufré dans la manufacturing of corrugated paper boxes in the province; province; Atten du que Iesdites requf tes ont été publiées Whereas the said petitions have been publish- dans la Gazette tfficielle de Québec, éditions des 11 ed in the Quebec Official Gazette, issues of January et 18 Janvier 1958; 11 and 18, 1958; Attendu que l'objection formulée a été appré- Whereas the objection set forth has been duly ciée conformément à la Loi; considered, as required by the Act; ( Il est ordonne, en conséquence, sur la propo- It is ordered, therefore, upon the recommen- sition de l'honorable Ministre du Travail: dation of the Honourable the Minister of Labour: Que ledit décret, numéro 728, soit modifié That the said decree, number 728, be amended comme suit: as fcllrws: 1° Les deux parties ccrtractantes de première 1.The following two contracting parties of Îart suivantes: \"Canadian Wire bound Boxes the first part: \"Canadian Wi rebound Boxes imitcd\" ct \"Shirpirg Ccrtairers Limited\" sont Limited\" and \"Shipping Containers Limited\" biffées et remplacées par les suivantes: are deleted and replaced by the following: \"Bal hurst Containers.Limited (Montreal \"Bat hurst Containers limited (Montreal Plant)\" Plart)\" .I \"Bathurst Containers Limited (St.Laurent \"Bathurst Containers Limited (St.Laurent Plant)\".Plant)\".J 2° L'Association Internationale des Machin is- 2.The International Association of Machi- tes.local 2033.de Sherbrccke, est acceptée comme nists, Local No.2033, of Sherbrooke, is accepted partie co-contractante de deuxième part.as co-contracting party of the second part.3° Les paragraphes \"a\", \"6\", \"c'^et \"d\" de 3.Paragraphs \"o\", ,46\", \"c\" and \"d\" of article l'article II, sont biffés et remplacés par les sui- II, are deleted and replaced by the following: { vanU: Taux minimum Sexes Masculin Féminin Minimum raie» \"II a) Salariés \u2014 Employees: Sexes Male Female Sou s-cont re malt re \u2014 Assistant-foreman.,.$1.37 $1.14 Machine à gaufrer \u2014 Corrugating machine: Gauf reur \u2014 Operator.:.1.50 Gaufreur temporaire \u2014 Temporary operator.1.40 Découpeur \u2014 Slitter and knife.1.40 Mécanicien de machine à coller \u2014 Double backer.T .35 Receveur et \"Shafter\" de rouleau \u2014 Tailer & rool shafter.1.20 Machine à imprimer et à rainer \u2014 Printer-slotter machine: Mécanicien \u2014 Operator.1.40 Assistant-mécanicien \u2014 Assistant-operator.1.30 Receveur et fournisseur \u2014 Tailer & feeder.1.25 Presse à imprimer (sur la longueur) \u2014Printing press machine (long-way): Mécanicien \u2014 Operator.1.35 Receveur\u2014 Tailer.1.25 0.99 Machine à rainer: Grosses bottes \u2014 Large box slotting machine: Raineur - Operator.1.35 Receveur \u2014 Tailer.1.20 0.99 Machine à rainer: Petites bottes \u2014 Small box slotting machine: Reineur \u2014 Operator.1.25 1.04 Receveur \u2014Tailer.1.20 0.99 Machine à découper les bottes et marqueuse-mitrailleuse (première opération) \u2014 Box slitting and scoring machine (first way) : Découpeur \u2014 Operator.1.32 Receveur \u2014 Tailer.1.20 Machine à découper les feuilles, marqueuses-mit rai lieuse (divers) \u2014 Sheet slitting and scoring machine (miscellaneous) : Mécanicien \u2014 Operator.1.32 Receveur \u2014Tailer.1.20 0.99 Machine combinée à découper et à rainer lés divisions \u2014 Combination partition slitter-slotter: * Mécanicien \u2014 Operator.1.30 Receveur \u2014 Tailer.1.20 0.99 Machine simple à rainer les divisions \u2014 Plain partition slotter: Raineur \u2014Operator.1.25 1.04 Receveur \u2014 Tailer.1.20 0.99'- Machine à assembler les divisions \u2014 Partition assembly machine: .Mécanicien \u2014 Operator.'.?.1.30 Fournisseuse \u2014 Feeder.0.99 Receveuse \u2014 Tailer.0.99 1652 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 Taux minimum Sexes Masculin Féminin Minimum rates Sexes Male Female Assemblage et divisions \u2014 Partition assembly: Assembleuse \u2014 Assembler.#.0.99 Machine à découper les pans \u2014 Flap cutting machine: Découpeur \u2014 Operator.1.29 1.04 Receveur \u2014 Tailer.1.20 0.99 Machine à plier et à appliquer la toile gommée \u2014 Folder-taper: Mécanicien \u2014 Operator.:.1.38 Receveur et inspecteur \u2014 Tailer & inspector.;-;.1.04 Machine automatique à appliquer la toile gommée \u2014 Automatic taping machine: Mécanicien \u2014 Operator.1.30 Aide \u2014Helper.1.20 .Receveur et inspecteur \u2014 Tailer & inspector.1.20 1.04 Machine semi-automatique à appliquer la toile gommée \u2014 Semi-automatic taper: Mécanicien \u2014 Operator.1.04 Receveur et inspecteur \u2014 Tailer & inspector.0.99 Pliage de bottes \u2014 Box folding: Plieuse \u2014 Folder.0.99 Machine à appliquer la toile gommée à la main \u2014 Hand taper: Mécanicien \u2014 Operator.0.99 Machine automatique à plier et à piquer \u2014 Automatic folder-stitcher: Piqueur \u2014 Operator.1.35 Fournisseur \u2014 Feeder.1.20 Machine semi-automatique à piquer \u2014 Semi-automatic stitcher machine: Piqueur \u2014 Operator.1.25 1.04 Machine à piquer à la main \u2014 Manual stitching machine: Pîqueu r \u2014 Operator.1.25 1.04 Presse à découper \u2014 Die press machine: Découpeur \u2014 Operator.1.35 Aide et éplucheur \u2014 Helper & stripper.1.20 0.99 Scie à ruban \u2014 Band saw: Préposé à la scie à ruban \u2014 Operator.1.20 1.04 Machine à remonter et à couper (S.F.) \u2014 (S.F.) Rewinder and cutter:.Mécanicien \u2014 Operator.1 \u2022 25 1.04 Receveur \u2014 Tailer.v.1.20 0.99 Enveloppement et ficelage \u2014 Building and tying: Préposé au ficelage \u2014 Tier.1.20 0.99 Matières adhésives \u2014 Adhesive unit : Préposé à la colle \u2014 Operator.1-30 Presses à rebuts \u2014 Waste baling press: Presseur \u2014 Operator.1-25 Aide \u2014Helper.120 Manutention de rouleaux \u2014 Roll handling: Premier préposé à la manutention \u2014 Chief roll hanlder .1.35 Préposé à la manutention motorisée \u2014 Power roll handling Operator.1.35 Manutenteur \u2014 Roll handler.1.20 Manutention générale \u2014 Handling general : Préposé au camion-empileur motorisé \u2014 Powered lift truck operator.1.35 Machines non cl as si fiée s \u2014 Non classified machines: Mécanicien \u2014 Operator.1 \u2022 25 1.04 Fournisseuse \u2014 Feeder.0.99 Expédition \u2014 Shipping department: Expéditeur \u2014 Slipper.1 \u2022 45 Assistant-expéditeur \u2014 Assistant shipper.1-35 Vérificateur \u2014 Checker.1-25 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.'.1-35 Aide\u2014Helper.120 Entretien \u2014 Maintenance : Homme de métier \u2014 Tradesman.1.45 Mécanicien \u2014 Mechanic.'.1.45 Aide aux hommes de métier \u2014 Tradesman's helper.\\.1.30 Huileur \u2014Oiler.-1.30 Concierge \u2014Janitor.1.20 Chambre de bouilloires \u2014 Boiler room: Mécanicien de machines fixes \u2014 Stationary engine m an: 2ème classe \u2014 2nd class.1.60 3ème classe \u2014 3rd class.1.50 4ème classe \u2014 4th class.1.40 Travail général \u2014 General labour: L'échelle de base de salaire pour le travail général est la suivante \u2014 The basic wage scale for general labour shall be as follows: Aide général \u2014 General labour.1.10 0.9o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1653 b) Salarié» (sexe masculin): Nonobstant la cédule de salaire apparaissant au présent article, le salaire minimum moyen des salariés du sexe masculin ne doit pas être inférieur à $1.25 de l'heure.c) Salariés (sexe féminin): Nonobstant la cédule de salaire apparaissant au présent article, le salaire minimum moyen des salariés du sexe féminin ne doit pas être inférieur à $1.00 de l'heure.d) Zone II: Les taux de salaire sminima et les moyennes de salaires minima pour les salariés de la Zone II sont cinq cents ($0.05) de moins que ceux mentionnés dans les paragraphes \"a\", ,lb\" et \"c\" du présent article.\" 4° L'article IV, est biffé et remplacé par le suivant: 'TV.Semaine de travail; Surtemps: Travail de nuit: a) La durée du travail pour tous les salariés, à l'exception des mécaniciens de machines fixes et les chauffeurs de bouilloires, est de quarante et une heure (41) par semaine.Les heures de travail de l'équipe de jour sont réparties entre 7.00 a.m.et 6.00 p.m.Tout travail exécuté les jours de congé et les dimanches ou, en plus de quarante et une heure (41) par semaine par ces mêmes salariés, doit être rémunéré à raison de salaire et demi; mais tout travail exécuté et payé au taux de salaire et demi, lesdits dimanches et jours de congé, n'est pas inclus dans les heures de travail hebdomadaire, au moment de calculer le temps supplémentaire de la semaine.b) Nonobstant les limites d'heures spécifiées au paragraphe \"a\" du présent article, la durée hebdomadaire du travail des mécaniciens de machines fixes et des chauffeurs de bouilloires (stokers) est de quarante-cinq (45) heures.Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces derniers ont droit à une (1) journée de repos pour chaque six (6) jours de travail.Tout travail exécuté le septième (7) jour consécutif de travail, les jours de congé et les dimanches ou en plus de quarante-cinq (45) heures par semaine par ces mêmes salariés, doit être rémunéré à raison de salaire et demi; mais tout travail exécuté et payé au taux de salaire et demi lesdits dimanches et jours de congé, n'est pas inclus dans les heures de travail hebdomadaire au moment de calculer le temps supplémentaire de la semaine.c) Travail de nuit: Les heures des équipes de nuit sont réparties comme suit: 2ième équipe: entre 2.00 p.m.et 1.00 a.m.3ième équipe: entre 11.00 p.m.et 8.00 a.m.Tout salarié travaillant avec la seconde équipe doit recevoir une prime de trois cents ($0.03) de l'heure et tout salarié travaillant avec la troisième équipe doit recevoir une prime de cinq cents ($0.05) de l'heure, pour travail de nuit.Toutefois, cette prime pour travail de nuit ne s'applique pas dans le cas des salariés de l'équipe de jour requis de travailler une partie du temps de la seconde équipe.La prime pour travail de nuit ne s'applique pas dans aucun autre calcul de paye.\" L.DÉSILETS, 47682-o Greffier du Conseil Exécutif.b) Male employees: Notwithstanding the preceding schedule of wages, the minimum average wage for male employees shall not be less than $1.25 per hour.c) Female employees: Notwithstanding the preceding schedule of wages, the average minimum wage for female employees shall not be less than $1.00 per hour.d) Zone II: The minimum rates and minimum averages for employees of Zone II shall be five ($0.05) cents less than those mentioned.in the foregoing paragraphs \"a\", \"b\" and \"c\".\" 4.Article IV, is deleted and replaced by the following: \"IV \u2014 Work week \u2014 Overtime \u2014 Night work: a) The regular work week for all employees, with the exception of stationary enginemen and firemen (stokers), shall be forty-one (41) hours per week.The hours of work of the day shift shall be distributed between 7.00 a.m.and 6.00 p.m.Any hours worked on holidays and Sundays, or any hours worked in excess of forty-one (41) hours in any one week by such employees, shall be paid at the rate of time and one half, but hours worked and paid at the rate of time and one half on said holidays and Sundays, will not be included in the total weekly hours worked when computing the weekly overtime.b) Notwithstanding the hourly limits specified in subsection \"a\" of the present section, the work week of stationary enginemen and firemen (stokers) shall be forty-five (45) hours.Notwithstanding the provisions of the preceding subsection, the aforesaid employees shall be entitled to one (1) day of rest for each six (6) days of work.Any work performed on the seventh (7th) consecutive day, on holidays or Sundays, and any hours worked in excess of forty-five (45) hours in any one week by such employees shall be paid at the rate of time and one half, but any hours worked and paid at the rate of time and one half on such holidays and Sundays, will not be included in the total weekly hours worked when computing the weekly overtime.c) Night work: The hours of work of the night shifts shall be distributed as follows: 2nd shift: between 2.00 p.m.and 1.00 a.m.3rd shift: between 11.00 p.m.and 8.00 a.m.Any employee working on the second shift shall receive a shift premium of three cents ($0.03) per hour and any employee working on the third shift shall receive a shift premium of five cents ($0.05) per hour, for night work.However, this shift premium for night work shall not apply in the case of day works required to work part of the second shift.The shift premium for night work shall not be taken into account for any other calculation of pay.\" , L.DÉSILETS, 47682-o Clerk of the Executive Council. 1654 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 ARRÊTÉ EN CONSEIL ORDER IN COUNCIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÊCUTD?EXECUTIVE COUNCDL CHAMBER Numéro 342 ' Number 342 Section \"A\" Section \"A\" Québec, le 17 avril 1958.Quebec, April 17, 1958.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments of the decree relating à l'industrie et aux métiers de la construction to the construction industry and trades in the dans la région de Ri mou ski.region of Rimouski.Attendu que, conformément aux dispositions Whereas, pursuant to the provisions of the de la Loi de la convention collective (Statuts Collective Agreement Act (Revised Statutes of refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amen- Quebec 1941, chapter 163 and amendments), dements), les parties contractantes à la conven- the contracting parties to the collective labour tion collective de travail relative à l'industrie et agreement relating to the construction industry aux métiers de la construction dans la région de and trades in the region of Rimouski, rendered Rimouski, rendue obligatoire par le décret numéro obligatory by the decree number 802 of July 8, 802 du 8 juillet 1953, amendé par les arrêtés en 1953, amended by Orders in Council numbers conseil numéros 1202-A du 28 octobre 1953, 1202-A of October 28, 1953, 472-C and 775-B 472-C et 775-B des 6 mai et 28 juillet 1954, 522- of May 6 and July 28, 1954, 522-D and 996 of D et 996 des 11 mai et 14 septembre 1955, 47-B, May 11 and September 14, 1955, 47-B, 48-H, 48-H, 503-H et 625-B des 18 janvier, 9 mai et 503-H and 625-B of January 18, May 9 and June 6 juin 1956, 354-D, 643-A, 643-B et 961-D des 6, 1956, 354-D, 643-A, 643-B and 961-D of April 4 avril, 26 juin et 18 septembre 1957, ont pré- 4, June 26 and September 18, 1957, have peti-senté au Ministre du Travail une requête à tioned the Minister of Labour to submit to the l'effet de soumettre à l'appréciation et à la consideration and decision of the Lieutenant-décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil Governor in Council some amendments to the certaines modifications audit décret; said decree; Attendu que ladite requête a été publiée Whereas the said petition has been published dans la Gazette officielle de Québec, édition du 1er in the Quebec Official Gazette, issue of March 1, mars 1958; 1958; Attendu Qu'aucune objection n'a été formu- Whereas no objection has been made against lée contre l'approbation des modifications pro- the approval of the proposed amendments; posées; Il est ordonné, en conséquence, sur la pro- It is ordered, therefore, upon the recommen- position de l'honorable Ministre du Travail: dation of the Honourable the Minister of Labour: Que ledit décret, numéro 802, soit modifié That the said decree, number 802, be amended comme suit: as follows: \u2014 1° L'article IV est remplacé par le suivant: 1.Article IV is replaced by the following: \"IV.Taux de salaires: Les taux de salaires \"IV.Rates of tcages: The following minimum minima suivants doivent être payés pour cha- rates of wages shall be paid for each one of the cun des métiers ci-après.De plus, ces taux trades hereafter mentioned.These rates shall seront majorés de SO.10 l'heure à compter du be increased by $0.10 from May 1st, 1959: 1er mai 1959; Salaires horaires Hourly rates Zones I II III Métiers \u2014 Trades: Briqteur, maçon et plâtrier \u2014 Bricklayer, mason and plasterer.$1.70 $1.65 $1.55 Calfat \u2014Caulker.1.30 1.25 1.15 Charpentier-menuisier \u2014 Carpenter-joiner.1.60 1.55 1.45 Compagnon junior 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.55 1.50 1.40 Électricien \u2014 Electrician: Entrepreneur (services personnels) \u2014 Contractor (personal services).2.25 2.15 2.05 Compagnon \u2014 Journeyman.1.65 1.60 1.50 Ferblantier-couvreur \u2014 Tinsmith-roofer: Compagnon \u2014 Journeyman.1.60 1.55 1.45 Compagnon junior, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.50 1.45 1.35 Fer et bronze d'ornementation \u2014 Ornamental iron and bronze: Mécanicien ou forgeron \u2014 Mechanic or blacksmith.1.60 1.55 1.45 Compagnon junior, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.50 1.45 1.35 Foreur \u2014 Driller.1.45 1.40 1.30 Gratteur, polisseur et sableur de plancher à la main ou à la machine \u2014 Floor scraper, polisher and sander, hand or machine.1.50 1.45 1.35 Isolement de laine minérale, soufflage par pression \u2014 Steel wool insulation, blower method: Chef d'équipe \u2014 Chief operator.1.60 1.55 1.45 Assistant du chef d'équipe \u2014 Assistant operator.1.50 1.45 1.35 Aide \u2014Helper.1.25 1.20 1.10 Jointoyeur, finisseur de ciment \u2014 Joint pointer, cement finisher.1.55 1.50 1 .\"30 Manoeuvre, faiseur de mortier, brasseur de célanite, couleur de blanc, porteur d'oiseau \u2014 Labourer, mortar maker, celanite mixer, plaster pourer, hod carrier.1.25 1.20 1.10 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1655 Salaires horaires Hourly rates Zones Métiers\u2014Trades: I II III Mécanicien de machines fixes et portatives \u2014 Engineman (stationary or portable).t.1.45 1.40 1.30 Mécanicien en isolement d'amiante \u2014 Asbestos insulation mechanic.1.60 1.55 1.45 Peintre \u2014Painter.1.55 1.50 1.40 Compagnon junior 1, an \u2014 Junior journeyman, one year.1.45 1.40 1.30 Polisseur de terrazzo à la machine \u2014 Terrazzo polishing machine operator.1.40 1.35 1.25 1er semestre \u2014 1st six months.1.30 1.25 1.20 Poseur de lattes (bois ou métal) \u2014 Lather (wood or metal).1.45 1.40 1.30 Poseur de tuiles, marbre et terrazzo \u2014 Tile, marble and terrazzo setter.1.55 1.50 1.40 Compagnon junior, 1 an \u2014 Junior journeyman, one year.1.45 1.40 1.30 Préposé aux malaxeurs ou compresseurs \u2014 Mixer or compressor operator: 7 pieds cubes ou plus \u2014 7 cubic feet or more.1.50 1 .,35 1.25 moins de 7 pieds cubes \u2014 under 7 cubic feet.1.25 1.20 1.10 Préposé aux monte-charge non actionnés par la vapeur \u2014 Freight elevator operator (not steam driven).1.40 1.35 1.25 Préposé au marteau pneumatique \u2014 Air hammer operator.1.40 1.35 1.25 Préposé aux tracteurs ou grues \u2014 Tractor or crane operator.1.60 1.45 1.35 Tailleur de pierre sur chantier de construction \u2014 Stone cutter on construction job.\u2022.1.70 1.65 1.55 Êpandeur d'asphalte \u2014 Asphalt spreader.1.80 1.75 1.65 Rateleur d'asphalte \u2014 Asphalt raker.1.65 1.60 1.50 Aide rateleur d'asphalte \u2014 Asphalt raker's helper.1.45 1.40 1.30 Préposé au rouleau compresseur (2 à 5 tonnes) \u2014 Asphalt roller operator (2 to 5 tons).1 55 1.50 1.40 Préposé au rouleau compresseur (8 à 12 tonnes) \u2014 Asphalt roller operator (8 to 12 tons).1.65 1.60 1.60 Gréeur \u2014 Rigger.1.65 1.50 1.40 Forgeron \u2014 Blacksmith.1 45 1.40 1.30 Préposé à la pelle mécanique (qualifié) \u2014 Shovel operator (qualified).1.70 1.65 1.55 Aide conducteur de pelle mécanique \u2014 Shovel operator's helper.1.50 1.45 1.35 Porteur d'eau \u2014 Water carrier.;.0.75 0.75 0.75 Soudeur (gaz ou électricité) \u2014 Welder (gas or electricity).1.65 1.60 1.50 Conducteur de tracteur RD8 \u2014 Tractor (RD8) operator.1.70 1.65 1.55 Apprenti, 1ère année \u2014 Apprentice, 1 st year.1.30 1.25 1.15 Apprenti, 2ème année \u2014 Apprentice, 2nd year.1.45 1.40 1.30 Conducteur de tracteur RD 6 ou 7 \u2014 Tractor (RD 6 or 7) operator.1.60 1.55 1.45 Préposé aux autres tracteurs \u2014 Operator of other tractors.1.56 1.60 1.40 Poseur de linoléum \u2014 Linoleum layer.1.55 1.50 1.40 Apprenti, 1ère année \u2014 Apprentice, 1st year.1.25 1.20 1.10 Couvreur: composition, gravier, sable asphalte \u2014 Roofer: composition, gravel, sand, asphalt.-.1.40 1.35 1.25 Préposé aux bouilloires (asphalte de couverture) \u2014 Kettleman (roofing asphalt).1.40 1.35 1.25 Polisseur de terrazzo à sec \u2014 Terrazzo polisher (dry).1.55 1.50 1.40 1er semestre \u2014 1st six months.1.45 1.40 1.30 Gardien sur chantier (nuit et jour, dimanche et fête) maximum 72 heures par semaine \u2014 Watchman on job (night and day, Sundays and holidays) maximum of 72 hours per week.;.;.1.05 1.05 1.05 Chauffeur de camion employé directement par les entrepreneurs de l'industrie de la construction \u2014 Truck driver employed directly by construction con- .tractors.».1.25 1.20 1.10 Par semaine (maximum 60 heures) \u2014 Per week (maximum of 60 hours).63.00 59.50 54.50 Plombier \u2014 Plumber: Entrepreneur, services personnels \u2014 Contractor (personal services).2.25 2.15 2.05 Compagnon \u2014 Journeyman.1.65 1.60 1.50, Compagnon junior, 1 an \u2014 Junior journeyman (1 year).1.45 1.40 1.30 Soudeur en tuyauterie \u2014 Pipe welder.1.60 1.55 1.45 Contremaître qui dirige au moins cinq (5) Foreman in charge of at least five (5) men: hommes: 10.10 l'heure de plus que le taux de SO.10 per hour over the rate of his trade, son métier.Contremaître qui dirige dix (10) hommes et Foreman in charge of ten (10) men or more: plus: 10.25 l'heure de plus que le taux de son SO.25 per hour over the rate of his trade.\" métier.\" 2° L'article VI est remplacé par le suivant: 2.Article VI is replaced by the following: \"VI.Jours chômés: Il n'y a pas de travail les \"VI.Holidays: There shall be no work on dimanches, le Premier jour de l'an, l'Epiphanie, Sundays, New Year's Day, Epiphany Day, St.la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Travail et la Jean Baptiste Day, Labour Day and Christmas Noël.En cas de nécessité, le travail exécuté Day.In cases of necessity, work performed ces jours-là doit être rémunéré à raison du bouble on these days shall be paid at the rate of double du salaire régulier.\" time.\" 3° Le paragraphe \"j\" de l'article IX est rem- 3.Paragraph \"j\" of article IX is replaced by placé par le suivant: the following: \"j) Taux de salaire des apprentis: Les taux \"j) Wage rates of apprentices: The following shall horaires minima sont les suivants: be the minimum wage of rates of appren-tices: 1656 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 ¦Apprenti briqueteur, maion et plâtrier: Apprentice bricklayer, mason and plasterer: 1ère Sème Sème année année année 1st 2nd 3rd year year year Zone I.W.90 SI.20 $1.45 Zonell.0.85 1.15 1.40 Zone III.0.75 1.05 1.30 Autres apprentis \u2014 Other apprentices: Zone I.0.85 1.05 1.25 Zone II.0.80 1.00 1.20 Zone III.0.70 0.90 1.10 Ces taux doivent être majorés de $0.10 l'heure The above rates shall be increased by $0.10 à compter du 1er mai 1959.\" per hour from May 1, 1959.\" 4° Le paragraphe \"b\" de l'article XII est 4.Paragraph \"6\" of article XII is replaced remplacé par le suivant: by the following: \"b) Salaire minima: Les taux de salaires \"6) Minimum wages: The minimum wage minima sont les suivants et ces taux seront rates shall be as follows and such rates shall be majorés de $5.00 par semaine à compter du increased by $5.00 per week from May 1,1959: 1er mai 1959: Par semaine \u2014 Per week Zones Métiers\u2014Trades: I II-III Compagnon (ouvrier qualifié) \u2014 Journeyman (skilled worker).$57.50 $53.00 Journalier (ouvrier non qualifié) \u2014 Labourer (common worker).49.50 48.50\" 5° L'article XIV est remplacé par le suivant: 5.Article XIV is replaced by the following: \"XIV.Durée du décret: lie décret demeure en ^\"XV/.Duration of the decree: The decree vigueur jusqu'au 30 avril 1960.II se renouvelle remains in force until April 30, 1960.It then automatiquement d'année en année par la suite renews itself automatically from year to year à moins que l'une des parties contractantes ne unless one of the contracting parties notified donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire the other party, in writing, to the contrary, not au plus tard le 1er janvier de l'année 1960 ou de later than January 1st, 1960 or January 1st of toute année subséquente.Les parties contrat- any subsequent year.The contracting parties tantes conviennent de commencer les négocia- agree to enter into negotiations regarding amend- tions relatives aux amendements à être apportés ments to be made to the decree in the course of au décret, au cours du mois de novembre qui November preceding the date of the annual Êrecede la date de l'expiration annuelle du décret, expiration of the decree.In the event of a notice tans le cas d'une dénonciation, copie de l'avis of termination, copy thereof shall also be filed doit être également adressée au Ministre du with the Minister of Labour.\" Taravail.\" L.DÊSILETS, L.DÉSILETS, 47682-o Greffier du Conseil Exécutif.47682-o Clerk of the Executive Council.Avis divers Avis est donné au public, conformément à l'article 8 de la Loi du régime des eaux courantes, que \"The James Maclaren Company, Limited\", de la ville de Buckingham, dans le comté de Papineau, se propose de demander l'autorisation de faire construire un bâtiment pour un moulin à entailler et écorcer à Poupore Lock sur la rivière du Lièvre, sur le cours d'eau qui borde et traverse une partie du lot huit (8) rang un est, canton de Portland, comté de Papineau, province de Québec.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant, l'emplacement choisi pour la construction ci-dessus, a été transmise au ministre des Ressources Hydrauliques, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la division d'enregistrement dans le comté de Papineau, à Papi-neauville, Québec.La demande contenue dans la requête, sera Erise en considération le ou après le jour suivant i date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Buckingham, Québec, le 3 avril 1958.The James Maclaren Company, Limited, Le Secrétaire, 47510-15-4-o J.W.THOMSON.Miscellaneous Notices Public notice is hereby given, in accordance with section 8 of the Water-Course Act, that \"The James Maclaren Company, Limited\", of the town of Buckingham, county of Papineau, intends to apply for authorization to have constructed a, slasher and debarking mill at Poupore Locks, on the Lièvre River on the water course which borders upon and passes across lot 8, range I east, township of Portland, county of Papineau, Province of Quebec.Notice is also- given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications of such work showing the site chosen for the construction thereof has been forwarded ta the Minister of Hydraulic Resources, and that a duplicate of such plan and specifications has been deposited at the registry office of the registration division of the county of Papineau, at Papineau-ville, Quebec.The application contained in the petition will be taken into consideration on or after the day following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Buckingham, Quebec, April 3, 1958.The James Maclaren Company, Limited, J.W.THOMSON, 47510-15-4-o « Secretary. ) Avis de constitution d'une compagnie d'assurance Avis est, par les présentes, donné que messieurs : A.Kenneth Robertson, Oak Ridge, Baie d'Urfé, P.Q., Ernie J.Corse-Scott.1320 Lombard Crescent, Ville Mont-Royal, P.Q., Olivier P.Garneau, 5130, avenue Westhill, Notre-Dame-de-GrAce, P.Q., Walter E.Montgomery, 85, avenue Kin-dersley.Ville Mont-Royal, P.Q., Michael E.Corse-Scott, 1250, rue Villeray, Montréal, P.Q., ont l'intention de présenter au Lieutenant-Gouverneur en conseil une requête ayant pour objet de les constituer en compagnie d'assurance conformément aux dispositions des articles 2 et suivants de la Loi des assurances (chapitre 299, R.S.Q., 1941), sous le nom de \"Le Bouclier Canadien, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Canadian Shield General Insurance Company\", dont le siège social sera dans la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal, ayant un capital actions d'un million de dollars ($1,000,000.00) divisé en dix mille (10,000) actions d'une valeur au pair de cent dollars ($100.00) chacune et ayant les pouvoirs de réaliser des opérations d'assurance et de réassurance relatives aux catégories suivantes: aérienne, cautionnement, dommages aux biens, maritime, responsabilité, personne, excepté l'assurance et la réassurance sur la vie.Donné à Montréal, ce 8ième jour d'avril 1958.Signature des requérants: ERNLE J.CORSE-SCOTT, OLIVIER P.GARNEAU, A.KENNETH ROBERTSON, MICHAEL E.CORSE-SCOTT, WALTER E.MONTGOMERY.47521-15-4-0 (Sec.P.270-58) Avis d'Autorisation .(Loi des Compagnies Minières de Québec) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Silver City Petroleums Ltd.\" a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, titres, certificats-actions, debentures et autres valeurs.Le siège social dans la province est 354 ouest, rue Notre-Dame, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle, est M.T.Palmer Howard, avocat, de Ville Mont-Royal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 30e jour d'avril 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 47656-o JEAN BRUCHÊSL (P.G.12982-56) Mannibec Ltée Mannibec Ltd.(Directeurs) Article 1 \"l* Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de cinq à sept, de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de sept directeurs.2° La majorité des directeurs formeront quorum à chaque assemblée du bureau de direction.Notice of formation of an assurance company Notice is hereby given that Messrs: A.Kenneth Robertson, Oak Ridge, Baie d'Urfé, P.Q., Ernie J.Corse-Scott.1320 Lombard Crescent, Town of Mount Royal, P.Q., Olivier P.Garneau, 5130 Westhill Avenue, Notre Dame de Grâce, P.Q., Walter E.Montgomery, 85 Kindersley Avenue, Town of Mount Royal, P.Q., Michael E.Corse-Scott, 1250 Villeray Street, Montreal, P.Q., intend to present to the Lieutenant-Governor in Council a petition for the purpose of constituting them into an insurance company in accordance with the provisions of sections 2 and following*of the Quebec Insurance Act (chapter 299, R.S.Q.1941), under the name of \"The Canadian Shield General Insurance Company\u2014 Le Bouclier Canadien, Compagnie d'Assurances Générales\", with head office in the city of Montreal, judicial district of Montreal, and a share capital of one million dollars ($1,000,000.00) divided up into ten thousand (10,000) shares of a par value of one hundred dollars ($100.000) each and with the powers to transact the following classes of insurance and reinsurance: aviation, damage to property, liability, marine, suretyship, persons, except life assurance and reassurance.Given at Montreal, this 8th day of April 1958.Signatures of the petitioners: ERNLE J.CORSE-SCOTT, OLIVIER P.GARNEAU, A.KENNETH ROBERTSON, MICHAEL E.CORSE-SCOTT, WALTER E.MONTGOMERY.47521-15-4-0 (P.Sec.270-58) Notice of Authorization (Quebec Mining Companies' Act) Notice is hereby given that the company \"Silver City Petroleums Ltd.\" has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The head office in the Province is at 354 Notre-Dame Street, West, in the City and Judicial District of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against it is Mr.T.Palmer Howard, advocate, of the Town of Mount Royal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of April, 1958.JEAN BRUCHÊSL 47656 Under Secretary of the Province.(A.G.12982-56) Mannibec Ltée Mannibec Ltd.(Directors) Article 1 \"1.The number of Directors of the Company be and the same is hereby increased from five to seven, so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of seven Directors.2.The majority of the Directors shall form a quorum at each Meeting of the Board of Directors.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1958, Vol.90, No.18 1657 1658 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 3° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.\" Décrété ce 10e jour de mars 1958.Vraie copie certifiée, 11 mars 1958.Le Secrétaire, 47659 E.PETER LOUGHEED.(P.G.13061-57) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, Thonorable Secrétaire de la province a, le vingt-cinq avril 1958, approuvé les règlements généraux de \"L'Association Sportive des Policiers d'Asbestos Incorporée\", tels qu'adoptés à l'assemblée générale tenue le 27 février 1958, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-six avril 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 47675-o JEAN BRUCHÊSL (P.G.7045-45) Occupational Therapy & Rehabilitation Centre Extrait du règlement numéro ' A\" tel qu'adopté à l'assemblée annuelle des membres de ladite corporation tenue le 26 février 1958, concernant une augmentation des membres, de son bureau de direction de trois à vingt-cinq: \"Règlement II \u2014 Bureau de direction: \u2014 1° Le bureau de direction sera composé de 25 membres de la corporation.\" Vraie copie certifiée.Le Secrétaire honoraire, 47676 ELIZABETH BECK NEWCOMB.Chartes \u2014 Abandon de 3.AU prior by-laws, resolutions or proceed ings of the Company are hereby amended, mo\" dified and revised in order to give effect to this By-law.\" Enacted this 10th day of March, 1958.Certified a true copy, March 11, 1958.E.PETER LOUGHEED, 47659-o Secretary.(A.G.13061-57) Notice is given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, on the twenty-fifth day of April 1958, the Honourable the Provincial Secretary has approved the general by-laws of \"L'Association Sportive des Policiers d'Asbestos Incorporée\", such as adopted at a general meeting held February 27, 195S, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-sixth day of April 1958.JEAN BRUCHÉSI, 47675 Under Secretary of the Province.(A.G.7045-45) ~ Occupational Therapy & Rehabilitation Centre Extract of by-law number \"A\", as adopted at the annual meeting of the members of the said Corporation held on February 26th, 1958, concerning an increase in the directorate thereof from three to twenty-five: \"By-law H \u2014 Board of Directors: \u2014 1.The Board of Directors shall be composed of 25 members of the corporation.\" Certified true copy.ELIZABETH BECK NEWCOMB, 47676-0 Honorary Secretary.Charters \u2014 Surrender of Martin Construction Limitée Avis est donné conformément à la loi des Compagnies de Québec, que la compagnie \"Martin Construction Limitée\" demandera au Procureur Général de la Province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Chicoutimi, ce 3ième jour de mars 1958.Les Procureurs de la compagnie, 47661-o DUFOUR & TREMBLAY.Prenez avis que la compagnie \"Desca Limitée\", compagnie légalement constituée d'après la Loi des Compagnies de la Province de Québec, ayant sa principale place d'affaires dans la cité de Montréal, demandera au Procureur Général delà Province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Daté ce lOième jour de mars 1958.Le Secrétaire, 47683-o R.O.De CARUFEL.Martin Construction Limitée Notice is hereby given that the company \"Martin Construction Limitée\" will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Chicoutimi, this 3rd day of March, 1958.DUFOUR & TREMBLAY, 47661-o Attorneys for the Company.Notice is hereby given that \"Desca Limitée\", a corporation constituted under .the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 10th day of March 1958.R.O.De CARUFEL, 47683-o Secretary.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.282-58) Avis est, par les présentes, donné que \"Pet Milk Company\", une compagnie à fonds social étrangère constituée en vertu des lois de l'état Delaware, E.U.A., a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, confor- Company Licensed to do Business (P.Sec.282-58) Notice is hereby given that \"Pet Milk Company\", an extra-provincial company incorporated in virtue of the laws of the State of Delaware, U.S.A., has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the pro- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May Sri, 1958, Vol.90, No.18 1659 mément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q.1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est à chambre 1210, 360 ouest, rue St-Jacques, enfles cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle, est M.Jacques Tétrault, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 30e jour d'avril 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 47656-0 JEAN BRUCHESL visions of the Extra-Provincial Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 279.The principal office of the said Company in the Province is to be at Room 1210, 360 St.James Street, West, in the City and Judicial District of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Jacques Tétrault, of the said City of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of April, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 47656 Under Secretary of the Province.Compagnies dissoutes (P.G.13087-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Abattoirs Leclerc Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 juin 1954.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un mars 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656-0 _ P.FRENETTE.(P.G.10499-58) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Citadelle Transport et Entreposage Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 23 octobre 1954: Avis est de plus donné qu'à compter du quinze avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47656-o P.FRENETTE.Companies Dissolved (A.G.13087-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Abattoirs Leclerc Limitée\", incorporated by letters patent dated June 22, 1954.Notice is also given that from and after the thirty-first of March 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April 1958.P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10499-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Citadelle Transport et Entreposage Ltée\", incorporated bv letters patent dated October 23, 1954.Notice is also given that from and after April fifteenth, 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this April twenty-fifth, 1958.P.FRENETTE, 47656 Acting Deputy Attorney General.Département de l'Instruction Publique N° 911-56.' Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Notre-Dame-du-Laus, dans le comté de Papineau, les lots 14 à 23 du rang I; 20 à 23 des rangs H et HI et 1 à 23 du rang IV du cadastre officiel du canton Wabasse, pour les annexer à la municipalité scolaire, de Notre-Dame-de-Pont main, dans le comté de Label le.Québec, le 21 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47629-17-2-o O.J.DESAULND3RS.Department of Education No.911-56.Application is made to detach from the school municipality of Notre-Dame-du-Laus, in the county of Papineau, lots 14 to 23, range I; 20 to 23 of ranges II and IH and 1 to 23 of range rV of the official cadastre of the township of Wabasse, in \"order to annex them to thé school municipality of Notre-Dame-de-Pontmain, in the county of Labelle.Quebec, April 21, 1958.A O.J.DÊSAULNŒRS, 47629-17-2 Superintendent of Education.N° 452-55.No.452-55.Demande est faite de détacher de la munici- Application is made to detach from the school palité scolaire de St-Célestin N° 2, dans le comté municipality of St.Célestin No.2, in the county de Nicolet.les lots 244 à 276 inclusivement et of Nicolet, lots 244 to 276 inclusive and 283 to 283 à 375 inclusivement du cadastre officiel de la 375 inclusive of the official cadastre of the parish 1660 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 paroisse St-Célestin, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Céjestin N° 1, même comté.Québec, le 21 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47630-17-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1078-55.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 17 avril 1958, de former une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de \"La municipalité scolaire de Saint-Jude, dans le comté de St-Hyacinthe\" et qui comprendra le territoire actuel des deux municipalités scolaires de Saint-Jude et Salvail, même comté.Ce changement prendra effet 1er juillet 1958.Québec, le 24 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47058-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 579-57.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 17 avril 1958, d'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"La municipalité scolaire de Carignan, dans le comté de Laviolette\", le territoire ci-dessous décrit qui n'est pas encore organisé au point de vue scolaire: 1° Les cantons Carignan et Boucher en entier; 2° les rangs A, B, C et I à V inclusivement du canton Turcotte; 3° les rangs I, II, III du canton Polette; 4° cette partie des cantons Malhiot et Vallières, décrite comme suit, savoir: les lots 51 à 68 inclusivement du rang I du canton Vallières; les lots 51 à 69 inclusivement et le bloc \"H\" du rang I du canton Malhiot et toute cette partie dudit canton limitée au sud-ouest, au sud-est et au nord-est par les limites actuelles dudit canton et à l'ouest par la ligne est du rang I du canton Malhiot.Ce changement prendra effet le 2 mai 1958.Québec, le 24 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47658-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 612-51.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 17 avril 1958, de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Bruno, dans le comté du Lac St-Jean, les lots 13 à 22 inclusivement et la demie nord du lot 23 du rang II et 13 à 22 inclusivement du rang III du canton Sinaï, pour les annexer à la municipalité scolaire d'Hébertville Station, même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Québec, le 24 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47658-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1160-57.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 17 avril 1958, de détacher de la municipalité scolaire d'Ely-Nord, dans le comté de Shefford, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Ste-Christine, dans le comté de Bagot.Les lots suivants, tous inclusivement du cadastre officiel du canton d'Ely, savoir: 925 à 936; 875 à 887; 808 à 818; 730 à 756; 636, demie-ouest, 637, demi-ouest et 641 à 656.of St.Célestin, in order that they be annexed to the school municipality of St.Célestin No.1, same county.Quebec, April 21, 1958.O.J.DÊSAULND3R, 47630-17-2 Superintendent of Education.No.1078-55.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated April 17, 1958, to form a new school municipality under the name of \"The School Municipality of Saint Jude, in the County of St.Hyacinthe\" and will include the present territory of the two school municipalities of Saint Jude and Salvail, same county.This change shall take effect on July 1st, 1958.Quebec, April 24, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 47658 Superintendent of Education.No.579-57.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated April 17, 1958, to erect into a separate school municipality under the name of \"The School Municipality of Carignan, in the County of Laviolette\", the territory hereinunder described which is not as yet organized for school purposes: 1.The townships of Carignan and Boucher in their entirety; 2.Ranges A, B, C and I to V inclusive of the township of Turcotte; 3.Ranges I, II, III of the township of Polette; 4.that part of the townships of Malhiot and Vallières, described as follows: lots 51 to 68 inclusive, range I of the township of Vallières; lots 51 to 69 inclusive and block \"H\", range I of the township of Malhiot and all that part of said township bounded southwesterly, southeasterly and northeasterly by the present limits of said township and westerly by the easterly line of range I of the township of Malhiot.This change shall take effect on May 2, 1958.Quebec, April 24, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 47658-o Superintendent of Education.No.612-51.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated April 17, 1958, has been pleased to detaclt from the school municipality of Saint-Bruno, in the county of Lake St-John, lots 13 to 22 inclusively, and the northern half of lot 23 of range II and 13 to 22 inclusively of range III of the SinaT township, to annex them to the school municipality of Hébertville Station, same county.This change in Council will take effect on July 1st, 1958.Quebec, April 24, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 47658 Superintendent of Education.No.1160-57.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated April 17, 1958, to detach from the School Municipality of Elry-North, in the county of Shefford, the territory hereinunder described in order that it be annexed, for Catholic ratepayers only, to the School Municipality of Ste.Christine, in the county of Bagot.The following lots, all inclusive of the official cadastre of the township of Ely, to wit: 925 to 936; 875 to 887; 808 to 818; 730 to 756; 636, westerly half, 637 westerly half and 641 to 656. _QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1661 N° 174-58.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 17 avril 1958, de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de St-Gabriel-de-Brandon, dans le comté de Berthier, les lots 96 à 113 inclusivement du cadastre officiel de St-Gabriel-de-Brandon, pour les annexer à la municipalité scolaire de Mandeville, dans le même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Québec, le 25 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47658-o O.J.DÉSAULNIERS.No.174-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated April 17, 1958, has been pleased to detach from the school municipality of the parish of St-Gabriel-de-Brandon, in the county of Berthier, lots 96 to 113 inclusively in the official cadaster of St-Gabriel-de-Brandon, to annex them to the school municipality of Mandeville, in the same county.This change will take effect on July 1st, 1958.Quebec, April 25, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 47658 Superintendent of Education.N° 1182-56.No.1182-56.ERRATUM L'avis publié dans la Gazette officielle de Québec des 14 et 21 décembre 1957, concernant l'annexion de certains lots à la municipalité scolaire de St-Philippe-de-Philipsburg, dans le comté de Missisquoi, devrait se lire comme suit: \"Demande est faite de détacher de la munici- Ealité scolaire de St-Philippe-de-Philipsburg, dans ; comté de Missisquoi, les lots 74 et 75 du cadastre officiel de Philipsburg, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de St-Armand-Ouest, dans le même comté.Québec, le 28 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47681-0 O.J.DÉSAULNHîRS.ERRATUM This notice published in the Quebec Official Gazette on the 14th dan 21st of December last, concerning the annexation of certain lots to the school municipality of St-Philippe-de-Philipsburg, in the county of Missisquoi, should read as follows: Application is made to detach from the school municipality of St-Philippe-de-Philipsburg, in the county of Missisquoi, lots 74 and 75 of the official cadaster of Philipsburg, to annex them for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of St-Armand-West, in the same county.Quebec, April 28, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 47681 Superintendent of Education.N° 356-58.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité, scolaire de Duhamel-Ouest, dans le comté de Témiscamingue, à la municipalité scolaire de Ville-Marie^dans le même comté.Québec, le 28 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47692-18-2-0 O.J.DÉSAULNHÎRS.No.356-58.Application is made to annex the present territory of the School Municipality of Duhamel-West, in the county of Témiscamingue, to the School Municipality of Ville-Marie, in the same county.Quebec, April 28, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 47692-18-2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel du village de Bienville (municipalité de cité de Lauzon) division d'enregistrement de Levis.Avis est par la présente donné que les lots 12, 13-1, 13-2, 18, 217, 222 sont corrigés et le lot 245 est annule en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 15 avril 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47657-o A VILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of village of Bienville (municipality of city of Lauzon) registration division of Levis.Notice is hereby given that lots 12, 13-1, 13-2, 18, 217, 222 are corrected and lot 245 has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, April 15, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 47657-o Deputy Minister.Ce changement prendra effet au 1er juillet This change shall take effect on July 1st, 1958.1958.Québec, le 25 avril 1958.Quebec, April 25, 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.J.DÉSAULNIERS, 47658-0 O.J.DÉSAULND3RS.47658 Superintendent of Eudcation. 1662 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 ment de l'Assomption.Avis est par la présente donné que les lots 104-107, 104-109 et 104-110 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 avril 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47657-o A VILA BÉDARD.of l'Assomption.Notice is hereby given that lots 104-107, 104-109 and 104-110 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, April 10, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 47657-o Deputy Minister.Cadastre officiel du canton de Magog (munici- Official cadastre of the township of Magog (mu-palité d'Omervine) division d'enregistrement de nicipality of Omerville) registration division Stanstead.of Stanstead.Avis est par la présente donné que les lots 2-A-ll à 2-A-15 et 2-A-19 à 2-A-23 Rang XX (Bolton) sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 18 avril 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47657-0 AVILA BÉDARD.Notice is hereby given that lots 2-A-ll to 2-A-15 and 2-A-19 to 2-A-23 Range XX (Bolton) are cancelled in virtue of Article 2174 A of the Civil Code.Quebec, April the 18th, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 47657-o Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des métiers de la construction de Saint-Hyacinthe, établi en exécution du décret numéro 909 du 25 août 1955, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 386 du 24 avril 1958, section \"C\" le tout conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés.1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er mai 1958 au 30 avril 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: o) Tous les employeurs professionnels de l'Industrie de la Construction assujettis au décret numéro 909 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Tous les salariés de l'Industrie de la Construction régis par ledit décret numéro 909 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération.e) Tous les artisans régis par ledit décret numéro 909 et à ses amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yz de 1% du salaire établi par le décret pour le compagnon le moins rémunéré, selon leur métier.2.Mode de perception 2.Mode of collection En vue de faciliter la perception des cotisations, In order to facilitate the collection of these le Comité paritaire met à la disposition des assessments, the Parity Committee supplies the employeurs professionnels des formules de rap- professional employers with report forms on port sur lesquelles doivent être indiqués tous les which all particulars required by the said Parity Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Building Trades Parity Committee of Saint Hyacinthe, formed under decree No.909, of August 25, 1955, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.386 of April 24, 1958, part \"C\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned.1.Assessments The period of levy extends from May 1, 1958 to April 30, 1959; it is laid as follows: a) The professional employers of the construction industry governed by the decree No.909, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to l^ol 1% of their payroll (as regards their employees governed by the said decree.b) The employees of the construction industry governed by the decree No.909 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of their remuneration.c) The artisans governed by the decree No.909 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to M of 1% of the lowest wages established in the decree for a journeyman of their trade. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1958, Vol.90, No.18 1663 renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation, de.l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire.Ledit Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des Métiers de la Construction pour le comté de Saint-Hyacinthe pour la période comprise entre le 1er mai 1958 et le 30 avril 1959.LE comite paritaire des métiers de la construction de saint-hyacinthe État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er mai 1958 et le 30 avril 1959.Recettes: Cotisations (M de Employeurs professionnels.$ 7,000.00 Salariés.7,000.00 Artisans.800.00 Honoraires d'examens.750.00 Pénalités, divers.450.00 $16,000.00 Déboursés: Salaires des employés, inspections, frais de déplacements.$11,290.00 Loyer, taxes, éclairage, timbres-poste, téléphone, entretien du bureau, administration de banque, assurance chômage.1,520.00 Impression, papeterie, vérification, etc.780.00 Jetons de présence.660.00 Frais de déplacements des membres.530.00 Bureau des examinateurs.720.00 Frais judiciaires et professionnels.200.00 Divers et imprévus.300.00 $16,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 mai 1958.47682-o Committee shall be given.The professional employer shall complete and sign his report, and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments imposed on the employees by means of a deduction from their wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments imposed by the present bylaw are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee without notice.Five (5) days' notice shall be given to any professional employer or artisan refusing to pay or to give the necessary information to the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report covering its financial operations and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Building Trades Parity Committee of St.Hyacinthe for the period comprised between May 1, 1958, and April 30, 1959.The Building Trades Parity Committee of St.Hyacinthe Estimate of the receipts and disbursements for the period comprised between May 1, 1958 and April 30, 1959.Receipts: Assessments (}/% of 1%) : Professional employers.$ 7,000.00 Employees.7,000.00 Artisans.800.00 Examination fees.750 00 Penalties and miscellaneous.450.00 $16,000.00 Disbursements: Employees' salaries, inspection, travelling expenses.$11,290.00 Rent, taxes, lighting, postage, telephone, office maintenance, bank charges, unemployment insurance.1,520.00 Printing, Stationery, Audition, etc.780.00 Meeting expenses.660.00 Travelling expenses of members.530.00 Board of examiners.720.00 Judicial and professional fees.200.00 Miscellaneous and unforeseen expenses .300.00 $16,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 3, 1958.-47882 1664 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'Industrie de la Construction de Québec, établi en exécution du décret numéro 410 du 18 avril 1957 et amendements et chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret N° 390^du 14 avril 1954, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil, numéro 386 du 24 avril 1958, section \"D\", le tout conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er mai 1958 au 30 avril 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Tous les employeurs professionnels de 11ndustrie de la Construction assujettis au décret numéro 419 du 18 avril 1957 et amendements et tous les employeurs professionnels du Commerce et de l'Industrie du Bois Ouvré, assujettis au décret numéro 390 du 14 avril 1954 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ]/^ de 1% de la liste des salaires, bonis, allocations qu'ils versent à leurs salariés régis par lesdits décrets, sauf les gérants, surintendants et employés de bureau, 6) Tous les salariés régis par lesdits décrets numéros 419 et 390 et leurs amendements, sauf les gérants, les surintendants et les employés de bureau, sont tenus de verser au Comité paritaire une cotisation équivalente à ^ de 1% de leurs salaires, bonis et allocations.2.Mode de perception Tous les employeurs professionnels de l'Industrie de la Construction régis par ledit décret numéro 419 du 18 avril 1957 et tous les em- fdoyeurs professionnels du Commerce et de 'Industrie du Bois ouvré régis par ledit décret numéro 390, doivent percevoir pour le Comité paritaire, les cotisations imposées aux salariés, a même le salaire qu'ils sont tenus de payer à ceux-ci.Les employeurs professionnels régis par lesdits décrets doivent transmettre au Comité paritaire un rapport mensuel accompagné de leurs propres cotisations et des sommes perçues de leurs salariés; ce rapport doit être transmis au Comité paritaire au plus tard le 10 du mois suivant le mois pour lequel il est exigible.Conséquemment, les cotisations de mai sont payables le 10 de juin et ainsi de suite de mois en mou.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la Convention collective, le Comité Conjoint doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité Conjoint de l'Industrie de la Construction de Québec relativement à l'administration desdits décrets, pour la période comprise entre le 1er mai 1958 et le 30 avril 1959.NOTICE OP LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Construction Industry of Quebec, established, 419 of April 18, 1957, and amendments, and entrusted with the administration of the decree No.390 of April 14th, 1954, has been authorized by a by-law approved by Orders in Council number 386 of April 24, 1958, part \"D\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned : 1.Assessments The period, of levy extends from May 1, 1958 to April 30,1959; such levy is laid in the following manner: t a) All professional employers of the construction industry governed by the decree No.419 of April 18, 1957, as amended, and all professional employers of the woodworking trade and industry, subject to the decree No.390 of April 14, 1954, shall pay to the Parity Committee a sum equal to of 1% of the wages, bonuses and allowances paid to their employees governed by the said decree, excepting managers, superintendents and office employees.6) All employees governed by the decrees Nos.419 and 390, as amended, excepting managers, superintendents and office employees, shall pay to the Parity Committee an assessment equal to lA of 1% of their wages, bonuses and allowances.2.Mode of collection All professional employers of the construction industry governed by the said decree No.419 'of April 18,1957, as amended, and all professional employers of the woodworking trade and industry, subject to the decree No.390, shall collect for the Parity Committee the assessments owed by employees, from the wages payable to them.The professional employers governed by the said decrees shall forward to the Parity Committee a monthly report, together with their own assessments and the sums collected from the employees; such report shall be sent to the Parity Committee no later than the 10th day of the month following that for which it is exigible.For instance, the assessments for the month of May are payable on June 10, and so on, from month to month.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial activities on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Construction Industry of Quebec for the administration of the said decrees, for the period between May 1,1958 and April 30 1959. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1605 Comité Conjoint de l'Industrie de la Construction de Québec Joint Committee of the Construction Industry of Quebec État des recettes et des déboursés probables Estimate of the receipts and disbursements for pour la période comprise entre le 1er mai 1958 the period between May 1, 1958 and April et le 30 avril 1959.30, 1959.Recettes: Cotisations de 1%): Employeurs professionnels.$ 75,000.00 Salariés.75,000.00 Receipts: Assessments of 1%) : Professional employers.$ 75,000.00 Employees.75,000.00 $150,000.00 $150,000.00 Déboursés: Salaires: Secrétaire et personnel de bureau.$ 19,240.00 Inspecteurs (6).26,520.00 Vérificateurs (3).13,260.00 Dépenses de bureau.6,500.00 Inspection \u2014 voyages.9,500.00 Jetons de présence.3,200.00 Frais de déplacements.9,000.00 Bureaux des examinateurs.8,400.00 Frais légaux.1,800.00 Divers, imprévus.4,000.00 Fonds de pension.2,100.00 Audition des livres.400.00 Subvention à la Commission d'Apprentissage.75,000.00 Disbursements: Salaries: Secretary and office employees.$ 19,240.00 Inspectors (6).26,520.00 Auditors (3).13,260.00 Office expenses.6,500.00 Inspection, Transportation.9,500.00 Attendance fees.3,200.00 Travelling expenses.9,000.00 Board of Examiners.1.8,400.00 Legal fees.1,800.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.4,000.00 Pension fund.2,100.00 Audition.____.400.00 Subvention to Apprenticeship Commission.75,000.00 Note: L'excédant des déboursés sur les recettes au montant de.sera comblé à même la réserve de fonds du Comité.$178,920.00 Note: The excess of disbursements 28,920.00 over the receipts amounting to will be covered by the reserve fund of the Committee.$178,920.00 28,920.00 $150,000.00 $150,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 mai 1958.47682-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire des Employés de Commerce et de Bureau région du Lac Saint-Jean, établi en exécution du décret numéro 810, du 10 mars 1945, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 386 du 24 avril 1958, section \"E\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québe, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever dçs cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 5 mai 1958 au 3 janvier 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 810 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leurs listes de paye.b) Les artisans régis par le décret numéro 810 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yz de 1% du salaire établi dans ledit décret pour le salarié le moins rémunéré, suivant leur emploi.c) Les salariés régis par le décret numéro 810 et amendements doivent verser au Comité pari- GÊRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 3, 1958.47682-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of Commerce and Office Employees, Lake St.John District, formed under decree number 810 of March 10,1945, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 386 of April 24, 1958, part \"E\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned.1.Assessments The period of levy extends from May 5, 1958 to January 3, 1959; and applies as follows: a) Professional employers governed by the decree number 810, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to % of 1% of their payroll.b) Artisans governed by the decree number 810, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to pi 1% of the lowest wages established in the said decree for their occupation.c) \u2022Employees governed by the decree number 810, and amendments, shall pay to the Parity 1666 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Terne 90, N° 18 taire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les noms et adresses deleurs salariés, leurs fonctions, leurs années de service, les heures de travail, l'argent perçu au cours de la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire à tous les mois.¦ t , .L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.\u2022 \u2022 Le rapport accompagné des cotisations doit être adressé au Comité paritaire le ou avant le 10 de chaque mois.3.Rapport financier Selon les termes de la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit transmettre un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité paritaire des Employés de Commerce et de Bureau, région du Lac Saint-Jean, pour la période comprise* entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1958.Comité Paritaire des Employés nE Commerce et de Bureau, région du Lac Saint-Jean Êtafe des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1958.Recettes Cotisations de 1%): Employeurs professionnels.S 7,500.00 Salariés.7,500.00 Divers, pénalités, etc.1,000.00 $16,000.00 Déboursés Salaires.$ 3,400.00 Loyer.660.00 Jetons de présence.1,500.00 Frais de déplacement des délégués.1,500.00 Vérification.200.00 Frais légaux \u2022 \u2022 \u2022 .;.250.00 Frais de participation \u2014 congrès.1,500.00 Formation professionnelle.800.00 Dépenses \u2014 inspecteur.1,250.00 Assurance santé \u2014 hospitalisation.1,000.00 Administration générale.1,200.00 Divers et imprévus.2,740.00 $16,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.1M inistère du Travail, Québec, le 3 mai 1958.47682-o Committee a sum equivalent to ^ of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee provides the professional employers with report forms indicating the name and address of their employees, their functions, their years of service, the hours of labour, the money collected during the week and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall see to it that the reports be completed and sent to the Parity Committee every month.The professional employer shall retain, at the end of each week, from the wages of every one of his employees, the sums owed to the Parity Committee.The report of the professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.The committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The report, together with the assessments, shall be sent to the Parity Committee on or before the 10th day of each month.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report of its financial activities and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of Commerce and Office Employees, Lake St.John, district, for the period between January 1, 1958 and December 31, 1958.Parity Committee of Commerce and Office Employees, Lake St.John District Estimate of the receipts and expenses for the period between January 1, 1958 and December 31, 1958.Receipts Assessments of 1%): Professional employers.$ 7,500.00 Employees.7,500.00 Miscellaneous.1,000.00 $16,000.00 Disbursements Salaries.$ 3,400.00 Rent.660.00 Meeting expenses.1,500.00 Delegates' travelling expenses.1,500.00 Audition.200.00 Legal fees.250.00 Expenses re : congress.1,500.00 Professional training.800.00 Expenses \u2014 inspector.;.1,250.00 Insurance \u2014 health, hospitalization.1,000.00 General administration.1,200.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.2,740.00 $16,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 3, 1958.47682-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1667 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention Collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité conjoint de la Construction de Rimouski, établi en exécution du décret N° 802 du 8 juillet 1953, a été autorisé par l'arrêté en Conseil N° 386 du 24 avril 1958, Section \"F\", à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret de la façon suivante: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 30 avril 1958 au 30 avril 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels assujettis audit décret numéro 802 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les salariés assujettis audit décret numéro 802 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération.2.Mode de perceptio n En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotistaion de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité Conjoint de la Construction de Rimouski, pour la période comprise entre le 30 avril 1958 et le 30 avril 1959.NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby givesn notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the Construction Joint Committee of Rimouski, formed under decree No.802 of July 8, 1953, has been authorized by Order in Council No.386 of April 24, 1958, par \"F\", to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree, as follows: 1.Assessment* The period of levy extends from April 30, 1958 to April 30, 1959; it is laid as follows: a) Professional employers governed by the said decree, No.802 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to x/2 of 1% of their payroll for employees governed by the said decree.b) Employees governed by the said decree, No.802 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which shall be given all particulars required by the said Parity Committee.Professional employers shall complete and sign their report, and forward it to the Parity Committee every month.Professional employers shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of their employees by means of a deduction fron their pay.Professional employers shall forward their monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable; the report shall be sent together with assessments of professional employers and the sums payable to the Parity Committee by their employees.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The levy laid under the present by law in payable every month by the professional employer and the employee, without notice from the Committee.Should a professional employer refuse to give the necessary information, he will be given five (5) days' notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuant of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial operations on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Construction Joint Committee of Rimouski for the period between April 30, 1958 and April 30, 1959. 1668 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N* 18 Comité Conjoint de la Construction de Rimouski Construction Joint Committee of Rimouski État des recettes et des déboursés probables pour Estimate of the receipts and disbursements for la période comprise entre le 30 avril 1958 et le the period between April 30, 1958, and April 30 avril 1959.30,1959.Recettes* Cotisations (]/2 de 1%) : Employeurs professionnels.$10,190.00 Salariés.10,190.00 Honoraires d'examens.400.00 Amendes et retenues sur réclamations.150.00 Intérêts et bonis sur dépots.70.00 $21,000.00 Déboursés: Salaires des employés.- $9,000.00 Frais de déplacement \u2014 administration.4,000.00 Jetons de présence et frais de déplacement des membres.3,500.00 Service des examinateurs.400.00 Papeterie et approvisionnement de bureau.500.00 Entretien du mobilier et divers.200.00 Loyer.780.00 Taxes municipales.20.00 Assurances générales.100.00 Assu rance groupe.300.00 Vérification.200.00 Frais de voyage.2,000.00 $21,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 mai 1958.47682-o Receipts: Assessments (l£ of 1%) : Professional employers.$10,190.00 Employees,.10,190.00 Examination fees.400.00 Fines and deductions from claims.150.00 Interest and bonus on deposits.70.00 ?$21,000.00 Disbursements: Salaries of employees.$9,000.00 Travelling expenses\u2014administration.4,000.00 Meeting expenses and members' travelling expenses.3,500.00 Services of examiners ;.400.00 Stationery and office equipment.500.00 Furniture maintenance and miscellaneous .200.00 Rent.780.00 Municipal taxes.20.00 Insurance.100.00 Groupe insurance.300.00 Audition.-.200.00 Travelling expenses.2,000.00 $21,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour, Department of Labour, Quebec, May 3, 1958.47682-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint des Coiffeurs de Québec, établi en exécution du décret N° 44, du 14 janvier 1954, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil 386 du 24 avril 1958, section \"G\", le tout conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever les cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er mai 1958 au 1er mai 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 44 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y> de 1% de la liste des salaires fixes, commissions, bonis, allocations qu'ils versent à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans assujettis audit décret numéro 44 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% basée sur une rémunération hebdomadaire moyenne de $80.00 dans la zone I et de $70.00 dans les autres zones.Tout employeur ou employeur professionnel qui pratique lui-même l'un ou l'autre des métiers visés par le décret NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Com-mettee of Hairdressers of Quebec; formed under Decree No.44 of January 14, 1954, has been authorized by a regulation approved by Order in Council No.386 of April 24, 1958, Part \"G\", in pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from May 1, 1958, to May 1, 1959; it shall be applied as follows: a) Professional employers governed by the decree No.44, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% of the regular payroll, and of the commissions, bonuses and allowances paid to their employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the said decree, No.44, and amendments, shall pay to the Parity Committee an assessment of ^ of 1% based on an average weekly remuneration of $80.00 in zone I and of $70.00 in other zones.Every employer or professional employer who plies one of the trades governed by the decree No.44 is also considered, for the purposes of this régula- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1958, Vol.90, No.18 1669 numéro 44, est de plus considéré, aux fins du tion, as an artisan, présent règlement, comme un artisan.c) Les salariés régis par ledit décret numéro c) Employees governed by the said decree, 44 et amendements doivent verser au Comité No.44 and amendments, shall pay to the Parity paritaire une somme équivalente à \\4 de 1% Committee an amount equivalent to of 1% de leurs salaires fixes, commissions, bonis et of their regular wages and of their commissions, allocations.bonuses and allowances.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.Les artisans doivent également transmettre mensuellement au Comité paritaire, les cotisations qu'ils sont tenus de verser audit Comité.L'employeur professionnel doit transmettre un rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le dixième jour du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés, lie Comité a le pouvoir d'exiger Passer-mentation dudit rapport chaque fob qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail, aux dates suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité Conjoint des Coiffeurs de Québec, pour la période comprise entre le 1er mai 1958 et le 1er mai 1959.Comité conjoint des coiffeurs de Québec Siège social: 330 rue St-Roch, Québec État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er mai 1958 \u2022 et le 1er mai 1959.Recette»: Cotisations (H de 1%) : Employeurs professionnels.$ 7,000.00 Artisans.10,700.00 Salariés.7,000.00 Honoraires d'examens et carnets d'apprentissage.100.00 Pénalités et divers.200.00 $25,000.00 Déboursé»; Salaires: Employés de bureau.$ 8,444.00 Inspecteurs.7,585.00 2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the Purity Committee shall be given.Professional employers shall complete and sign their report and forward it to the Parity Committee every month.Professional employers shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of their employees by means of a deduction from their pay.Artisans shall also forward to the Parity Committee, every month, the assessments they are hereby required to pay.Professional employers shall submit their monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is rvquirable.The report shall be forwarded with (he assessments of professional employers and of employees.The Committee bus the right to exact sworn reports when deemed advisable.The levy imposed by the present regulation is payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to given the information required, he will be given five (5) days notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of Hairdressers of Quebec, for the period between May 1, 1958, and May 1, 1959.The Joint Committee of Hairdressers of Quebec Head Office: 330 St.Roch St., Quebec Estimate of the receipts and disbursements for the period between May 1, 1958, and May 1, 1959.Receipt»; Assessments (14 of Wo)' Professional employers.$ 7,000.00 Artisans.10,700.00 Employees.7,000.00 Examination fees and apprentice booklets.100.00 Penalties, miscellaneous.200.00 $25,000.00 Disbursements: Salaries: Office employees.$ 8,444.00 Inspectors.7,585.00 1670 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 Frais de déplacements: Inspecteurs.2,100.00 Administration.200.00 Loyer du bureau.625.00 Frais judiciaires et professionnels.1,100.00 Papeterie, impression et publicité.030.00 Timbres, téléphone et assurance-chd-] mage.800.00 Ameublement et accessoires de bureau.600.00 Assu rarce et frais de cautionnement.200.00 Frais de déplacement des membres et du président.260.00 Jetons de présence aux membres du Ccmité.5Ê0.0O Souscriptions et abonements.£96.00 Bu reau d'examinateurs.300.00 Dépréciation.60.00 Divers et imprévus.150.00 $25.000.05 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 mai 1958.47682-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux établissements commreciaux dans les villes de Dolbeau et Mistassini et un rayon de trois (3) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret numéro 621 du 20 niai 1953, lui ont présenté une requête ù l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret: Le paragraphe s) suivant sera ajouté à l'article \"«) Le mot \"artisan\" signifie toute personne qui expleite, seule ou en société, un établissement régi par le présent décret et qui n'emploie pas de salarié.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 3 mai 1958.47682-o Travelling expenses: Inspectors.2,100.00 Administration.700.00 Office rent.625.00 Legal fees.1.100.00 Stationery, printing and publicity.930T00 Postage, telephone and unemployment insurance.800.00 Furniture and office equipment.600.00 Insurance and fidelity bond.200.00 Travelling expenses of chairman and members.260.00 Meeting expenses of committee members.->.550.00 Subscript ions.596.00 Board of examiners.300.00 Dépréciât ion.60.00 Various and unforeseen expenses.150 00 $25.000.00 ERRATUM La version anglaise de l'avis de prélèvement concernant le Comité paritaire de l'industrie de la construction des comtés de Roberval, Lac St-Jean et Chicoutimi, publié dans la Gazette officielle de Québec du 12 avril 1958, page 1394, est corrigée comme suit: Les mots \"March 31, 1959\" apparaissant trois fois dans ledit avis doivent se lire \"May 31,1959\".Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, L Québec, le 3 mai 1958.47682-o GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 3, 1958.47082-O NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the'collective agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 adn amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to commercial establishments in the towns of Dolbeau and Mistassini and a radius of three (3) miles from their limits, rendered obligatory by the decree number 621 of May 20, 1953, have petitioned him to submit to the consideration and decision of theLieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: The following paragraph s) will be added to article I: \"*) The word \"artisans\" means any personne who operates, alone or in partnership, an establishment governed by the present decree and who has no employees.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 3, 1958.47682-o ERRATUM The English version of the notice of levy concerning the Parity Committee of the Construction Industry of the counties of Roberval, Lake St.John and Chicoutimi, published in the issue of April 12/ 1958 of the Quebec Official Gazette, page 1394, is corrected as follows: The date \"March 31, 1959\" appearing three times in the said notice of levy should read \"May 31, 1959\".^ GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour, Department of Labour, Quebec, May 3,1958.47682-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1671 Ministère des Finances Assurances Avis de changement de nom Avis est donné par les présentes que \"The Hanover Fire Insurance Company\", constituée en corporation conformément aux lois de l'État de New York.États-Unis d'Amérique, et enregistrée dans la province sous le numéro 289.a changé son nom eu celui de \"The Hanover Insurance Company\".Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 17 avril 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LA FRANCE, 47631-17-2-o Surintendant des assurances.Avis d*annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"Reliance Insurance Company of Philadelphia\", dont le siège social est situé à Philadelphie, État de Pennsylvanie.États-Unis d'Amérique, a été fusionnée par \"Fire Association of Philadelphia\", dont le siège social est situé à Philadelphie, État de Pennsylvanie.États-Unis d'Amérique, en vertu d'un acte de fusion en date du 13 décembre 1957, et qui a pris effet le 1er janvier 1958; Attendu que \"Fire Association of Philadelphia\", la corporation subsistante, est dûment autorisée à faire des affaires dans la province de Québec; Attendu que \"Reliance Insurance Company of Philadelphia\" s'est conformée aux dispositions dé l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de \"Reliance Insurance Company of Philadelphia\" sont annulés à compter du 17 avril 1958.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 17 avril 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 47632-17-2-0 Surintendant des assurances.Avis 'de changement de nom Avis est donné par les présentes (o) que \"Fire Association of Philadelphia\", constituée en corporation conformément aux lois de l'État de Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique, et enregistrée dans la province sous le numéro 228, a changé son nom en celui de \"Reliance Insurance Company\", et (6) que la compagnie n'est autorisée .à employer ce nom dans la province qu'à la condition de le faire suivre des mots \"of Philadelphia\".Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 24 avril 1958.Pour le Ministre des finances v de la province, GEORGES LAFRANCE, 47667-18-2-0 Surintendant des assurances.Department of Finance Insurance Notice or change or name Notice is hereby given that 'The Hanover Fire Insurance Company\", incorporated under the laws of the State of New York, United States of America, and registered in this Province under number 289, has changed its name to \"The Hanover Insurance Company\".Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 17th of April 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, ¦ 47631-17-2-o Superintendent of Insurance.Notice or cancellation or license .and registration Whereas \"Reliance Insurance Company of Philadelphia\", whose head office is situate in Philadelphia, State of Pennsylvania, United States of America, has been merged into \"Fire Association of Philadelphia\", whose head office is situate in Philadelphia.State of Pennsylvania, United States of America, under an agreement of merger dated December 13th, 1957, and that has taken effect on the 1st of January 1958; Whereas \"Fire Association of Philadelphia**, a company duly authorized to do business in this Province, is the resulting corporation; Whereas \"Reliance Insurance Company of Philadelphia\" has complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; f Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Reliance Insurance Company of Philadelphia\" is cancelled as from the 17th of April 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, on the 17th of April 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, .47632-17-2-0 Superintendent of Insurance.Notice or change or namb Notice is hereby given (a) that \"Fire Associa-' tion of Philadelphia\", incorporated under the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, United States of America, and registered in this Province under number 228, has changed its-name to \"Reliance Insurance Company\", and (b) that the company is authorized to use this name in the Province on the condition that it is followed by the words \"of Philadelphia\".Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 24th of April 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 47667-18-2-0 Superintendent of Insurance. V 1672 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 Nomination Appointment PRESIDENT D'ÉLECTION RETURNING-OFFICERS H a plû à son honneur le Lieutenant-gonver- His Honour the Lieutenant-Governor has been neur, de l'avis et du consentement du Conseil pleased, with the advice and consent of the execu- exécutif, par commission Sous le Grand Sceau, tive Council to appoint by commission under df faire, pour remplir la charge de président the Great Seal, to fill the office of returning- d'élection, la nomination suivante: officer, the person whose name follows: District electoral\tNom, prénoms\tProfession ou occupation\tDomicile .Electoral district\tName, christian names\tProfession or calling\tDomicile \tWarrén, Samuel (1)./.\tComptable-auditeur \u2014 Accountant-Auditor.\tPointe-au-Pic.\t\t\t (1) En remplacement de monsieur Edouard Boulianne, décédé.\u2014 In place, of Mr.Edouard Boulianne, deceased.Québec, le 28 avril 1958.Quebec, April 28th.1958.Le Président général des élections, FRANÇOIS DROUIN.Q.C., 47680-0 FRANÇOIS DROUIN, C.R.47680-O Chief Returning-Officer.Sièges sociaux Head Offices \"(P.G.10947-58) Les Entreprises Triangle Inc.Règlement N° 12 Concernant le changement de bureau principal Le bureau principal de la compagnie \"Les Entreprises Triangle Inc.\", est transporté de Montréal, district de Montréal, où il était auparavant, à Préville, district de Montréal, au numéro 22 de la rue Provence.Décrété, ce 11 février 1958.Copie certifiée conforme.Le Secrétaire, 47660-O MAURICE JOUBERT, INC.P.Les Entreprises Duvernat Ltée Avis est donné par les présentes que la Compagnie \"Les Entreprises Duvernay Ltée;\" constituée en corporation par lettres patentes émises le vingt-deux janvier 1958, et ayant son siège social dans la Cité de Montréal, a établi son bureau dans ladite cité au numéro 7881 Boulevard Décarie.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 22ième jour de janvier 1958.Le Secrétaire, MARGUERITE ROBERT 47662-o _ RAPONI.DÉCLARATION * \"L.M.Électrique Inc.\", fut incorporée par lettres patentes, en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, en date du 28 juin, 1957.Elle a commencé ses opérations, le 23 avril, 1958.Le bureau-chef de la compagnie est situé au No.413 Avenue du Parc, en la cité de Granby, district de Bedford, province de Québec.Et j'ai signé à Granby, ce 23 avril, 1958.47663-o Le Président, LIONEL MATHIEU.(A.G.10947-58) Les Entreprises Triangle Inc.By-law No.12 Concerning change of head office The head office of the company \"Les Entreprises Triangle Inc.\", is transferred from Montreal, district of Montreal, where it was heretofore, to Préville, district of Montreal, to number 22 Provence Street.Enacted, on February 11, 1958.' , Certified true copy.MAURICE JOUBERT, P.ENG., 47660 Secretary.Les Entreprises Duvernat Ltée Notice is hereby given that the Company \"Les Entreprises Duvernay Ltée\" constituted as a corporation by letters patent issued the twenty-second day of January 1958, and having its head office in the City of Montreal, has established its office in the said city at number 7881 Decarie Boulevard.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Given at Montreal, this 22nd.day of January 1958.MARGUERITE ROBERT RAPONI, 47662 Secretary.DECLARATION \"L.M.Électrique Inc.\", was incorporated by letters patent under Part I of the Quebec Companies' Act, dated June 28, 1957.It started its operations on April 23, 1958.The head office of the Company is located at No.413 Park Avenue, in the City of Granby, District of Bedford, Province of Quebec.And I have signed at Granby, this April 23, 1958._ LIONEL MATHIEU, 47663 President. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No; 18 ; 1673 f Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Spécialités Lucerne Specialties Inc.\", incorporée en vertu de la première, partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes émises le 26 mars 1958, a son bureau principal au N° 4566 de la rue De Lanaudière dans la cité de Montréal.Montréal, le 28 mars 1958.Le Secrétaire, 47664-0 LOUIS-PHILLPPE GAGNON.Avis d'adresse Avis est donné que la Compagnie \"Quebec Base Metals Exploration Ltd.(N.P.L.)\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 19 mars 1957, et ayant son bureau principal dans la Cité de Montréal, a établi son bureau au N° 1392 est, Sherbrooke.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la Compagnie comme * étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 24ième jour d'avril 1958.Le Président, 47665-0 JACQUES FORGET.(Sec.P.2937-54) Avis de changement du siège social (Loi des Compagnies à Fonds Social étrangères) Avis est, par les présentes, donné que \"Wil-ford & Me Kay, Incorporated\", une compagnie à fonds social étrangères dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, a dûment transmis au Secrétaire de,la province une copie d'une nouvelle procuration exécutée le 28 février 1958, confirmant la nomination de M.Cecil T.Teakle de 459 avenue Strath-con a, Westmount, Montréal 6, comme son agent principal dans cette province et déclarant que le bureau principal de ladite compagnie dans la province de Québec a été transporté de la cité de Montréal à l'adresse donnée ci-dessus, à savoir: 459 avenue Strathcona, Westmount, Montréal 6.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 25e jour d'avril 1958.Le Sous-secrétaire de la province.47677 JEAN BRUCHÊSL Avis de situation du siège social \"Universal Enterprises Limited\" Avis est donné par les présentes que la compagnie \"Universal Enterprises Limited\" constituée en corporation par lettres patentes émises le vingt-deux novembre, 1957, et ayant son siège social dans la cité de Montréal, a établi son bureau dans ladite cité au numéro 261 de la rue St-Jacques ouest.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est .considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 17ième jour d'avril, 1958.Le Président, 47678-0 CLAUDE DUCHARME.j.E.Stanbbury & Co.Ltd.^ Cette compagnie a été constituée en corporation par lettres patentes émises par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, en date du Notice is hereby given that the company \"Spécialités Lucerne Specialties Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent issued on March 26, 1958, at its head office, at No.4566 De Lanaudière Street, in the City of Montreal.Montreal, March 28,1958.LOUIS-PHHJPPE GAGNON, 47664 _ Secretary.Notice or address Notice is hereby given that \"Quebec Base Metals Exploration Ltd.(N.P.L.)\" company incorporated by letters patent on March 19th 1957, and having its head office in the City off Montreal, has established its office at ' 1392 Sherbrooke Street east.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 24th day of April 1958.JACQUES FORGET, 47665-0 President.(P.Sec.2937-54) Notice or change or head officb (Extra-Provincial Companies* Act) \u2022 Notice is hereby given that \"Wilford & Me Kay, Incorporated\", an extra-provincial company duly licensed to do business in the Province of Quebec, has duly transmitted, to the Provincial Secretary, a copy of a new power off attorney executed on February 28th, 1958 confirming the constitution of Mr.Cecil T.Teakle of 459 Strathcona Avenue, Westmount, Montreal 6.as its chief agent in this Province, and declaring that the principal office of the said company in the Province of Quebec has been changed from the City of Montreal to the above given address, namely: 459 Strathcona A venae, Westmount, Montreal 6.< Given at the office of the Provincial.Secretary this 25th day of April, 1958.JEAN BRUCHÊSI, :: 47677-o Under Secretary of the Province.Notice of location of head office \"Universal Enterprises Limited\" Notice is hereby given that the company \"Universal Enterprises Limited'* constituted at a corporation by letters patent issued the twenty-second day of November, 1957.and having its head office in the City of Montreal, has established its office in the said City at number 261 St.James Street, West.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.¦\u2022 i Given at Montreal, this 17th.day of April 1958.CLAUDE DUCHARME,.47678 * President, i J.E.Stanbbury & Co.Ltd.This company was incorporated : by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, on Marh 12, 1958, and has 1074 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.S mai Î958, Tome 90,1V 18 19 mare 1958, et a établi son sièbe social à 1070 established its head office at 1070 Bleury Street, rue Bleury, en les cité et district de Montréal, in the city and district of Montreal, Province of province de Québec.Quebec.Montréal, 12 mars 1958.Montreal, March 12, 1958.47679 Le Secrétaire, GEORGE WHELAN.47679-0 GEORGE WHELAN, Secretary.John Schwartz Limited Cette compagnie a été, constituée en corporation par lettres patentes émises par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, en date du 7 mars 1957 et a établi son siège social à 5590 avenue Victoria, Montréal, Que.Montréal, 8 novembre 1957.' 47684 Le Secrétaire, LILLIAN SCHWARTZ.Arm db changement du siège social Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"A.S.McNichols & Co.Ltd.\u2014 A.S.McNichols & Cie Ltée\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 mars 1931, et ayant son siège social en la province de Québec, à Montréal, où jusqu'il cette présente date, il était situé au numéro 132 ouest, rue St-Jac-ques Ta transporté au numéro 4374 rue De la Roche.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.- Donné à' Montréal, ce vingt-huitième jour d'avril 1958.(Sceau) 47685 Le Secrétaire, LOUISE McNICHOLS.John Schwartz Limited This company was incorporated by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec on March 7, 1957, and has established its head office at 5590 Victoria Avenue.Montreal.Que.Montreal, November 8,1957.47684-0 LILLIAN SCHWARTZ, Secretary, Notice or change or head office Notice is hereby given that the company \"A.S.McNichols & Co.Ltd.\u2014 A.S.McNichols & Cie Ltée\", incorporated by letters patent dated March 3, 1931, and having its head office in the Province of Quebec, at Montreal, where its head office was situated until this present date, at number 132 St.James Street West, has transferred it tri number 4374 De la Roche Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered .by the company as being its head office.Given at Montreal, this twenty-eighth day of April, 1958.(Seal) LOUISE McNICHOLS.47685-o Secretary.AyiS est donné que la compagnie \"Tracteur Radisson Inc.\u2014 Radisson Tractor Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec en date du 16 avril 1958 aura sa principale place d'affaires au no 5 rue Hackett à Granby.A compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Granby.le 22 avril 1958.(Sceau) 47604-o Le Secrétaire, JACQUES BOUCHARD.Notice is hereby given that \"Tracteur Radisson Inc.\u2014Radisson Tractor Inc.\", company incorporated by letters patent issued under the part 1st of the Quebec Company's Act, on the 16th day of April 1958, has his head office at 5 Hackett Street Granby.> From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office.Dated at Granby, this 22nd day of April 1958.(Seal) JACQUES BOUCHARD, 47694-o Secretary.Ridwood Lumber & Builders Supplies Ltd.Redwood Lumber & Builders Supplies Ltd.Avis du changement du siège social .Avis est donné que \"Redwood Lumber & Builders Supplies Ltd.\", .constituée en corporation le 2 août 1955 et ayant autrefois son siège social à Montréal, a établi son nouveau siège social à 6, Montée Massom à St-Vindent-de-Paul, dans le district de Montréal.St-Vincent-de-Paul, le 25 avril 1958.La Secrétaire, 47695-0 CLAIRE FOURNIER-LACROIX.Notice of the Change in the Address of the Head Office Notice is hereby given that \"Redwood Lumber & Builders Supplies Ltd.\", company incorporated on the 2nd day of August, 1955, and formerly having its head office in Montreal has moved its said head office to 5 Montée Masson, St.Vincent de Paul, in the District of Montreal.St.Vincent de Paul, April 25th, 1958.CLAIRE FOURNIER-LACROIX, 47695-0 \u2022 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May Sri, 1968, Vol.90, No.18 1675 Examen du Barreau -r- Bar Examination BARREAU DE SAINT-FRANÇOIS \u2014 BAR OF ST.FRANCIS Candidats aux examens d'admission à la pratique on droit Candidates to the examinations for admission to the practice op law Noms Names Allaire.Badeau.Bergeron.Boudreau Gobeil.Mélanson Prénoms Surnames Gerald.Claude.Léonard Gérard.Albert.Jean., Age 21 26 25 23 23 23 Residence Residence ) Magog.Sherbrooke Magog- Sherbrooke Sherbrooke Windsor.Collèges Colleges Université Université Université Université Université Université de Sherbrooke, de Sherbrooke, de Sherbrooke de Sherbrooke, de Sherbrooke, do Sherbrooke.Sherbrooke, ce 21 avril 1958 \u2014 Sherbrooke, April 21st, 1953.Le Secrétaire du Barreau de Saint-François, CHARLES LEBLANC, 47693-0 Secretary of the Bar of St.Francis.Soumissions Tenders Province de Québec Province of Quebec Les commissaires d'écoles pour la muni ci- The school commissioners for the municipalité de Ste-Julie palitt of Ste-Julib (Comté de Verchères) (County of Verchères) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions Kur obligations\" seront reçues par le soussigné, -R.Gauthier, secrétaire-trésorier, Ste-Julie, comté de Verchères, jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 20 mai 1958, pour l'achat de $140,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de Ste-Julie.comté de Verchères, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 22 mars 1958, telle que modifiée \u2014 reconstruction de l'école du village.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 1140,000.00 \u2014 90 an» Année Capital 1er juin 1959.x 125.500.00 1er juin 1960.x 26,500.00 1er juin 1961.x 28.000.00 1er juin 1962.2,500.00 1er juin 1963.2,500.00 1er Juin 1964.2,500.00 1er juin 1965.2,500.00 1er juin 1966 .3,000.00 1er juin 1967 .3.000.00 1er juin 1968.3,000.00 1er juin 1969.3,000.00 1er juin 1970 .3.500.00 1er juin 1971.3,500.00 1er juin 1972.,.4,000.00 1er juin 1973 .4,000.00 1er juin 1974.4,000.00 1er juin 1975 .4,500.00 \u2022 1er juin 1976.4,500.00 1er juin 1977.5,000.00 1er juin 1978 .5,000.00 Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned D.-R.Gauthier, Secretary-Treasurer, Ste-Julie, county of Verchères, until 8.00 o'clock p.m., Tuesday, May 20, 1958, for the purchase of an issue of $140,-000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of Ste-Julie, county of Verchères, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978, inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semiannually on June 1st and December 1st of each year.-The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated March 22, 1958, as amended \u2014 reconstruction of the village school.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from June 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 SlJfi.OOOW \u2014 SO years Year Capital June 1st, 1959.x 125,500.00 June 1st, 1960.x 26,500.00 June 1st, 1961.x 28.000.00 June 1st, 1962.June 1st, 1963.June 1st, 1964.June 1st, 1965.June 1st, 1966.June 1st, 1967.June 1st, 1968.June 1st, 1969.June 1st, 1970.June 1st, 1971.June 1st, 1972.June 1st, 1973.June 1st, 1974.June 1st, 1975.June 1st, 1976.June 1st, 1977.June 1st, 1978.2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3.000.00 3.000.00 3,000.00 3.000.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00 4.000.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 1676 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 181.528.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de $27,176.00 chacun, de 1959 à 1961 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste-Julie, comté de Verchères.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas {-achetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 20 mai 1958, à 8.00 heures du soir, au bureau du secrétaire-trésorier, Ste-Julie, comté de Verchères.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumission.Ste-Julie, (Comté de Verchères), ce 25 avril 1958.Le Secrétaire-trésorier, D.-R.GAUTHIER.Téléphone: 85 à Ste-Julie; ou CRescent 1-2476 à Montréal, Ste-Julie, (Verchères), P.Q.47666-0 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de beauport (Comté de Québec) Avis public est par les présentes drnné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions, pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-A.Gendrcn, secrétaire-trésorier, Académie Ste-Marie, 10, rue de l'Académie, Beau-port, comté de Québec, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 19 mai 1958, pour l'achat de $478,-000.00 d'obligations des cerrmissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Beauport, comté de Québec, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable' semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 23 septembre 1957 \u2014 construction d'une annexe à l'Académie Ste-Marie.The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $81,528.00 granted by the Provincial Secretary and payable m three instalments of $27,176.00 each, from 1959 to 1961 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque, payable at par at Ste-Julie, county of Verchères.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds are not redeemable by anticipation before June 1st, 1968 inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, May 20.1958.at 8.00 o'clock.p.m., at the office of the Secretary-Treasurer, Ste-Julie, county of Verchères.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Ste-Julie, (County of Verchères), April 25, 1958, D.-R.GAUTHIER, Secretary-Treasurer.Telephone: 85 Ste-Julie; or CRescent 1-2476 at Montreal.Ste-Julie, (Verchères), P.Q.47666 Province of Quebec The school commissioners for the municipality or the town or Beauport (County of Quebec) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-A.Gendron, Secretary-Treasurer, Académie Ste-Marie, 10, Académie Street, Beauport, county of Quebec, until 8.C0 o'clock p.m., Monday, May 19th, 1958.for the purchase of an issue of $478,000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality, of the town of Beauport, county of Quebec, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semiannually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated September 23rd, 1957 \u2014 construction of an annex at the St.^Mary's Academy. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1958, Vol.90, No.18 1677 Pour fins d'adjudication seulement, le cakul For the purposes of awarding the issue only d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1958.computation* of interest will be made as from June 1st, 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 94.78,000.00 \u2014 £0 an».Annie Capital 1er juin 1959.x 1er juin 1960.z 1er juin 1961.x 1er juin 1962.x 1er juin 1963.1er juin 1964.1er juin 1965.1er juin 1966.1er juin 1967.1er juin 1968.1er juin 1969.1er juin 1970.1er juin 1971.1er juin 1972.1er juin 1973.1er juin 1974.1er juin 1975.1er juin 1976.1er juin 1977.1er juin 1978.181.000.00 85,000.00 88,500.00 92,500.00 6,000.00 6.000.00 6,500.00 6,500.00 7,000.00 7,000.00 7,500.00 8.000.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00 10.000.00 10.000.00 10,500.00 11,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $364,-261.76, accordé par le Secrétaire de la province et payable rn quatre versements de $91,065.44 chacun, de 1959 à 1962 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de c et emprunt.( L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Beauport, comté de Québec.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetahles par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement: apiès cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refendus «!e (Québec.1941, être rachetées par anticipât h n, en tout ou en partie, au pair, à toute e» béante d'intérêt; cependant, si tel rachat est paît ici.il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livrai-ton.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séant e des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 19 mai 1958, à 8.00 heures du soir, à l'Académie Ste-Marie, 10 rue de l'Académie, Beauport, comté de Québec.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Beauport, (Comté de Québec), ce 1er mai 1958.Le Secrétaire-trésorier, J.-A.GENDRON.Académie Ste-Marie, 10, rue de l'Académie, Beauport, (Québec), P.Q.Téléphone: MO-3-09Q9.47696-o Table of redemption \u2014 $478,000.00 \u2014 SO yean Year Capital June 1st, 1959.June 1st, I960.June 1st, 1961.June 1st, 1962.June 1st, 1963.June 1st, 1964.June 1st, 1965.June 1st, 1966.June 1st, 1967.June 1st, 1968.June 1st, 1969.June 1st, 1970.June 1st, 1971.June 1st, 1972.June 1st, 1973.June 1st, 1974.June 1st, 1975.June 1st, 1976.June 1st, 1977.June 1st, 1978.$81,000.00 85,000.00 88,500.00 92,500.00 6,000.00 6,000.00 6.500.00 6,500.00 7,000 :oo 7,000.00 7,500.00 8.000.00 8.000.00 8,500.00 9.000.00 9.500 00 10.000.00 10.000.00 10.500.00 11,000.00 The \"x\" indicate the years during which annual payments of \"a total amount of $364,261.-76.granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of $91,065.44 each, frcm 1959 to 1962 inclusively.^ will be received and applied to the service of this loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal anil accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Beauport, county of Quebec.Capital and interest'are payable at all branches in the Province of Quebec of the hank mentioned in the loan procedure, and at the main office of the said bank in Toronto.The said bonds shall not be callable before June 1st.1968 inclusively: after the latter date, the said bonds are.under the authority of Chapter 212.Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par.at any interest naturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, May 1 fith.1958,at8.00o'clockP.M., at the Académie Ste-Marie, 10, Academy Street, Beauport.county of Quebec.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Beauport,\" (County of Quebec) this 1st \"of May, 1958.2 J.-A.GENDRON, Secretary-Treasurer.Académie Ste-Marie, 10, Académie Street, Beauport, (Quebec), P.Q.Phone: MO-3-0909.47696-o 1678 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 mai 1958, Tom 90, N° 18 Vente d'effets non réclamés Sale of Unclaimed goods Avis est pur les présentes donné que tons les effets reçus avant le premier jour'de mai 1957, et non réclamés aux bureaux de la \"Canadian Prcific Express Compeny\" a' divers endroits de la province de Québec seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur nar Frank WaHdihffton, encanteur.à 128, rue King est, Tomrtn.Ontario, à ONZE heures du matin, le HUITIÈME jour de MAI 1958, conformé-ment A la boi des Chemins de fer du Canada, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal.Québec, le 21 mars 1958.- Canadian Pacific Express Company.Le Surintendant Général, 47414-13-6-o F.A.DOYLE.Notice is hereby given that all goods received previous to the fhst day of May, 1957, and still remaining unclaimed in the offices of the \"Canadian Pacific Express Company\" at different points in the Province of Quebec will he sold at public auction to the highest bidder by Frank Waddington.auctioneer, at 128 King Street East, Toronto, Ontario, at ELEVENTH o'clock in the forenoon, on the EIGHTH day of MAY, 1958 under authority of the Railway Act of Canada, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal.Quebec, this 21 st.March, 1958.Canadian Pacific Express Company.F.A.DOYLE, 47414-13-6-0 * General Superintendent.Ventes \u2014 Loi de faillite Sales \u2014 Bakrupcy Act Canada, Province de Québec, district de Québec, N° 5811-F.Dans la Cour Supérieure (En.matière de faillite).Dans l'affaire de: Charles Aimé Drolet (Drolet Tire Service.Enr.) Cap St-Ignace, comté de Montmagny, P.Q.VENTE A L'ENCAN Avis est par les présentes donné que MERCREDI, le VINGT-ET-UNIÊME jour de MAI, 1958.à ONZE heures A.M.sera vendu par encan public à la porte de l'église paroissiale de Cap St-Ignace.Co.Montmagny, P.Q.l'immeuble ci-après décrit, savoir: Ln terrain mesurant 85 pieds du sud au nord et 160 pieds de Test à l'ouest, borné à l'ouest au terrain de Georges Picard, au nord par le chemin public, à l'est et au sud au terrain de J.« O.Coulombe, lequel terrain est connu et désigné comme partie du lot No.228 aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Cap St-Ignace, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Cet immeuble sera vendu au plus haut et dernier enchérisseur à la charge des taxes municipales et scolaires et de toutes autres impositions foncières tant pour le passé que pour l'avenir.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux du syndic soussigné.Cette vente sera faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code de procédure civile et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: Argent comptant.Québec, ce 14 avril, 1958.Le Syndic, J.P.BEDARD.Bureau: 71, rue St-Pierre, Chambre 411, Québec.- 47558-16-2-o Canada, Province of Quebec, district of Quebec, No.5811 -F.In the Superior Court (In bankruptcy).In'the matter of: Charles Aimé Drolet (Drolet Tire Service Enr.), Cap St-Ignace, county of Montmagny, P.Q.AUCTION-SALE Notice is hereby given that on WEDNESDAY, MAY TWENTY-ONE, 1958, at ELEVEN o'clock A.M., will be sold by public auction, at the Church door of the parish of Cap St-Ignace, Co.Montmagny, P.Q.the immoveable property as follows A piece of land measuring 85 feet from south to north and 160 feet from the east to the west, bounded to the west to land of Georges Picard, to the north by the public road, at the east and south to the land of J.O.Coulombe, the said land is known and designated as part of lot No.228 to the' plan and official cadastre for the parish of Cap St-Ignace, with the buildings thereon erected, circumstances and dépendances.This immoveable property shall be sold to the last and highest bidder subject to municipal and scholar taxes and all impositions as much for the past as for the future.Titles and certificates may be examined at all time by applying to the offices of the undersigned trustee.This sale shall be made in accordance with articles 716, 717 and 719A of the code of civil procedure and also article 55 of the bankruptcy act.This sale is equivalent to a sale by Sheriff.Conditions of payment: Cash.Quebec, April 14th, 1958.J.P.BEDARD, Trustee.Offices: 71, St-Peter St., Room 411, Quebec.47558-16-2-0 Canada, Province de Québec, district de Chicoutimi, Cour Supérieure (En matière de Faillite).Dans l'affaire de la faillite de: Paul-Emile Morissette, ci-devant entrepreneur électricien et faisant affaires également sous les nom et raison sociale de \"Morissette Anten T.V.Enrg\" 456, St-Léon, Chicoutimi, P.Q., débiteur.Canada, Province of Quebec, district of Chicoutimi, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of the bankruptcy of: Paul-Emile Morissette, former master electrician carrying on business under the name and style of \"Morissette Anten T.V.Enrg\", 456 St.Léon, Chicoutimi, P.Q., debtor. / AVIS DE VENTE NOTICE OF SALE Avis est par les présentes donné que: VEN- Notice is hereby given that : FRIDAY, the DREDI, le VINGT-TROIS MAI 1958, A TWENTY-THIRD day of MAY 1958, at ELE- ONZE heures a.m.sera vendu par encan public, VEN o'clock a.m., shall be sold by public auc- i la porte de l'église de la paroisse du Sacré- tion, at the door of the church of the parish of Cœur du Bassin Chicoutimi, l'immeuble ci- Sacré-Cœur du Bassin Chicoutimi, the immo- après décrit, savoir: veable hereinafter described, to wit: Item A) Un lopin de terre de figure irrégulière > Item A) A plot of land of irregular shape form-formant partie du lot N° onze cent vingt-cinq ing part of lot No.eleven hundred and twenty-CP.1125) au cadastre officiel de la ville de Chi- five (P.1125) of the official cadastre of the town coutimi, mesurant environ 75 pi.de largeur du of Chicoutimi.measuring some 75 ft.in width sud-est au nord-quest, en front du côté nord-est, from the southeast to the northwest, in front on 32 pi.de largeur du côté sud-ouest, par 100 pi.the northeasterly side, 32 ft.in width on the de profondeur du nord-est au sud-ouest et 50 pi.southwesterly side, by 100 ft.in depth from the de profondeur sur les 43 pi.de largeur du côté northeast to the southwest and 50 ft.in depth sud-est dudit terrain et compris dans les bornes by 43 ft.in width on the southeasterly side of suivantes: Au nord-est par une rue de 50 pi.said piece of land and included in the following de largeur dont le propriétaire à l'usage à per- boundaries: Northeasterly by a street 50 ft.pétuité pour communiquer de son terrain à la wide, the owner of which has a user's right for rue Lévesque, au sud-ouest, partie par le terrain life in order to communicate between his land de M.Arthur Gagnon, fils, partie à la rue Ga- and Lévesque Street, southwesterly, partly by gnon, joignant d'un côté au sud-est partie au the land of Mr.Arthur Gagnon, Junior, party by terrain de Philippe Lapointe et partie au terrain Gagnon Street, adjoining on one side to the de M.Arthur Gagnon, fils et de l'autre côté au southeast, partly the land of Philippe Lapointe nord-ouest au terrain de M.Charles Morin, and partly the land of Mr.Arthur Gagnon, avec toutes les bâtisses dessus construites, cir- Junior, and on the other side to the northwest, Constances et dépendances, tel que le tout se the land qf Mr.Charles Morin, with all the trouve actuellement.buildings thereon erected, circumstances and dependencies, alhof which as it actually stands.L'item (A) sera offert en vente au plus haut > Item (A) shall be put up for sale to the last and et dernier enchérisseur à charge des rentes ainsi highest bidder subject to rents as well as the que des servitudes actives et passives.servitudes both active and passive.Les titres et certificats peuvent être examinés Titles and certificates may be examined at the aux bureaux des syndics soussignés.offices of the undersigned Trustees.Cette vente est faite conformément aux articles This sale is made in accordance with articles 716, 717 et 719A du C.P.C., aussi à l'article 55 716, 717 and 719A of the C.C.P.as well as article de la Loi de Faillite 1949.Cette vente équivaut 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale is i la vente faite par le Shérif.equivalent to a sale by Sheriff.Conditions de paiement: Argent comptant.Conditions of payment: Cash.Québec, ce 14 avril 1958.Quebec, April 14.1958.Les Svndics.LEFAIVRE.LABERGE.LEFAPVRE.LABERGE.MARMETTE & LEFAIVRE, .MARMETTE & LEFAIVRE.Trustees.111.Côte de la Montagne.Quéliec et 111 Mountain Hill.Quebec and 369 est, rue Racine, Chicoutimi.47561-16-2-o 369 Racine Street, East.Chicoutimi.47561-16-2 Cara^a, Provirce de Quebec.District de Que- Canala.Province of Quebec.District of Quebec.Co-»f Supérieure m«ti*re de faillite), bec.Superior Court (in the matter of Bank-Dans l'affaire de la faillite de: Hans Rolf, fai- nipcy).In the matter of the bankruptcy of sauI If commerce de boulangerie, pâtisserie «jus Hans Rolf.^carrying on a bakery and oonfec-les nom et raison sociale de \"Central Bakery thvery husress under the style and taTie of Re**d\" 400 Ave.Gamàche A Sept-Iles, comté \"Central Bakery Re**d\" 400 Gamaehe Ave., de Saguenay.débiteur.at Sept-Iles, county of Saguenay, debtor.N AVIS DE VENTE NOTICE OF SALE Avis est par les présentes donné que: MAR- Notice is hereby given that: TUESDAY, DI.le VINGT MAI 1958, A TROIS heures MAY TWENTIETH.1958, at THREE o'clock p.m., sera vendu par encan public A la porte p.m.shall he soli by public auction, at the de lé dise de la paroisse St-Jnseph de Sept-Iles.church door on the parish of St.Joseph of Sept- comté de Saguenay, l'immeuble ci-après décrit.Iles, county of Saguenay, the immoveable here- savoir: inafter descriVI, to wit: Item a) Un lot de terre connu et désigné sous Item a) A lot of land known and designated le N° huit cent vingt (820) du rang deux, d'à- under No.eight hundred and twenty (820) of près les plan et livre de renvoi officiel du calas- range two, accorling to the official plan and tre pour le Village de Sept-Iles.situé dans la book of reference for the cadaster of the Village ville de Sept-Iles, Canton Letellier.avec bâtis- of Sent-Iles, situated in the town of Sept-Iles, ses dessus construites, circonstances et dépen- Letellier township, with huit lings thereon erect-dances sans exception ni réserve.ed, circumstances and dependencies, without - exception nor reserve.Biens meubles Moveable property A 4.00 heures de l'après-mHi, soit le 20 mai At 4.00 o'clock in the afternoon, albeit the 1958.les syndics vendront sur les lieux A la place 20th of May, 1958, the Trustees shall be on the d'affaires du débiteur les biens meubles consis- premises at the business place of the debtor, tant en de la machinerie, de l'outillage etc.(pour the moveable property consisting of machinery, être vendus en détail).equipment, etc.(to be sold in detail).QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec*May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1679 1680 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N° 18 L'item (A) sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes ainsi que des servitudes actives et passives.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps aux bureaux des syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du C.P.C.et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, ce 16 avril 1958.Les Syndics, R.ERNEST LEFAIVRE, JOSEPH MARMETTE & Bureaux: RENÉ LEFAIVRE.111, Côte de la Montagne, Québec.47574-16-2-0 Item (A) shall be offered for sale to the highess and last bidder subject to the rents as well at the active and passive servitudes.Titles and certificates may be examined at any time by applying to the offices of the undersigned Trustees.This sale is made in accordance with articles 716,717 and 719A of the C.C.P., and also article.55 of the Bankruptcy Act, 1949.This sale is equivalent to a sale made by Sheriff.Conditions: cash.Quebec, April 16.1958.R.ERNEST LEFATVRE, JOSEPH MARMETTE & RENE LEFAIVRE, Offices: Trustees.Ill, Mountain Hill, Quebec.47574-16-2 Province de Québec, District de Joliette, Cour Supérieure, N* 631 (1956) \"En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Léonard Grégoire, Province of Quebec, District of Joliette, Superior Court, number 631 (1956) \"In bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of industriel, St-Esprit, Co.Montcalm, cédant au- Léonard Grégoire, industrialist, St-Esprit, Co.torisée; et Claude Perras, syndic.AVIS DE VENTE Montcalm, authorized Perras, trustee.assignor, and- Claude NOTICE OF SALE Avis public est par les présentes donné que Public notice is by these presents given that l'immeuble suivant, savoir: the following immoveables, to wit: Désignation Un morceau de terre à bois et de terre en culture, situé à St-Esprit, borné d'un bout par le chemin du Roi, de l'autre bout et d'un côté à Pacifique Pelletier, et de l'autre bout du reste de ladite terre h bois appartenant à Dame Aimé Venre, contenant un arpent et demi de largeur sur la lorgueur dudit terrain à bois, connu aux Slan et livre de renvoi officiels du cadastre de t-Esprit comme faisant partie du numéro quatre cent soixante-seize (P.numéro 476, avec les bâtisses y érigées; Sera vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Esprit, Co.Montcalm, à ONZE heures de l'avant-midi.heure avancée de l'est, JEUDI le VINGT-NEUF de MAI 1958.Cette verte est faite en vertu d'un jrgement rendu, par la Cour Supérieure à Joliette.le 3 mars 1958, et suivant les dispositions des articles 55 et suivants de la Loi de 1949 sur la faillite afin de denrer à cette vente l'effet du décret aux termes du Cede de procédure civile.Conditions: comptant.En plus du prix d'achat l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 2^% conformément à la Loi., Pour autres renseignements et cahier des charges s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 1958.Le Syndic.Bureau de CLAUDE PERRAS.PERRAS: & RAINVILLE, syndics, 4, est rue Notre-Dame, Montréal.47640-17-2-O Designation t A parcel of wooded land and cultivated land, situated at St-Esprit, bounded at one end by the King's highway, at the other end on one side, by Pacifique Pelletier, and on the other end by the remainder of the said wooded land belonging to Dame Aimé Venue, containing an arpent and one-half in width on the length of the said wooded land, krown on the official plan and in the bock of reference of the cadaster of St-Esprit as forming part of number four hundred and seventy-six (Pt.number 476, with the buildings thereon erected; Shall be sold at the parochial church door of St-Esprit.Co.Montcalm, et ELEVEN o'clock in the forenoon.Eastern Daylight Saving Time, THURSDAY, MAY TWENTY-NINTH.1958.This sale is made by virtue of a judgment rendered by the Superior Court at Joliette, March 3, 1958.and following the provisions of section 55 ans following of the Bankruptcy Act of 1949.so as to give to this sale the effect of a Sheriff's sale according to the terms of the Code of Civil Procedure.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the purchaser must pay Government rights of 2y£% in conformity with the law.For other information and list charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this seventeenth day of April, 1958.CLAUDE PERRAS, Office of Trustee.PERRAS & RAINVILLE, Trustees, 4 Notre-Dame St., East, Montreal, P.Q.47640-17-2 Province de Québec, district de Joliette, Cour Province of Quebec, district of Joliette, Su.Supérieure, N° 631 (1956) \"En faillite\".Dans perior Court, No.631 (1956) \"In bankruptcy\".1 affaire de la faillite de Léonard Grégoire, indus* In the matter of the bankruptcy of Léonard tnel,.Saint-Esprit, comté de Montcalm, ce- Grégoire, industrialist, Saint-Esprit, county of dant autorisée; et Claude Peiras, syndic.Montcalm, authorized assignor, and Claude Perras, trustee. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1958, Vol.90, No.18 1681 AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Désignation Un terrain connu comme faisant partie du lot numéro cent cinquante-deux (P.152) sur le plan et au livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Saint-Esprit, de forme parallélogramme ou quadrillatére, dont les deux côtés sont égaux deux à deux, dont la hauteur est de soixante pieds, mesure anglaise, et dont les deux côtés les plus longs mesurent deux arpents et demi, bornés dans l'un des petit côtés, par le chemin public, et dans les trois autres côtés, par le reste du même, lot n° 152.Ce terrain a être pris à côté d'un terrain semblable quant à la forme et aux dimensions, lequel est situé, voisin des lots nos 153 et 153a, du même cadastre; v Sera vendu à la porte de l'église paroissiale de Saint-Esprit, comté de Montcalm, à ONZE heures et TRENTE de l'avant-midi heure avancée de l'est, JEUDI le VINGT-NEUF mai 1958.Cette vente est faite en vertu d'un jugement rendu, par la Cour Supérieure à Joliette, le 3 mars 1958.et suivant les dispositions des articles 55 et suivants de la loi de 1949 sur la faillite afin de donner à cette vente l'effet du décret aux termes du Code de procédure civile.Conditions: comptant.En plus du prix d'achat l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 2)4% conformément à la loi.Pour autres renseignements et cahier des charges s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 1958.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: PERRAS & RAIN VILLE, Syndics, 4 est rue Notre-Dame, Montréal.47641-17-2-0 Province de Québec, district de Joliette, Cour Supérieure, N° 631 (1956) \"En faillite\".Dans l'affaire de la faillite de: Léonard Grégoire, industriel, St-Esprit, comté de Montcalm, cédant autorisé; et Claude Perras, syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que les immeubles suivants, savoir: Description \"1° Tous les droits, parts et prétentions qu'il a ou peut avoir sur des lots à bois, situés dans la paroisse de St-Calixte, connus sur le plan et au livre de renvoi officiels du cadastre du canton Kilkenny, comme faisant partie des lots numéros 6 B, six C, six D, et six E dans le troisième rang, bornés dans les deux bouts par les cordons, et des deux côtés par les terrains de l'acquéreur.2° Tous les droits, parts ou prétentions qu'il a'ou peut avoir dans et sur deux lots de terre situés en la paroisse de St-Calixte, connus et désignés sous les numéros 4A et 4B du septième rang du canton Kilkenny, d'après les plan et NOTICE OF SALE Public notice is by these presents given that the following immoveables, to wit: Designation A lot of land known as forming part of lot number one hundred and fifty-two (Pt.152) on the official plan and in the hook of reference for the parish of Saint-Esprit, in the form of a parallelogram or quadrilateral, the two sides of which are equal, two by two, the height of which is sixty feet, English measure, and of which both sides on the length, measure two arpents and one-half, bounded on one side of the small sides, by the public highway, and on the other three sides, by the remainder of the same lot.No.152.This lot to he taken by the side of a lot similar insofar as form and dimensions go.which is situated as a neighbor to lots Nos.153 and 153a, of the same cadaster; Shall be sold at the parochial church door of Saint-Esprit, county of Montcalm, at ELEVEN THIRTY, in the forenoon, Eastern Daylight Saving.Time, THURSDAY, MAY TWENTY-NINTH, 1958.This sale is made by_ virtue of a judgment rendered by the Superior Court at Joliette, March 3.1958.and following the provisions of section 55 and following of the Bankruptcy Act of 1949.so as to give to this sale the effect of a Sheriffs sale according to the terms of the Code of Civil Procedure.Conditions: cash.Over and above the purchase price, the purchaser must pay Government rights of 2)4% in conformity with the law.For other information and list charges, apply to the undersigned.Dated at Montreal, this seventeenth day of April, 1958.CLAUDE PERRAS, Trustee.Office of: PERRAS & RAINVILLE, trustees, 4 Notre-Dame St., East, Montreal, P.Q.47641-17-2 Province of Quebec, district of Joliette, Superior Court, number 631 (1956) \"In bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of Leonard Grégoire, industiralist, St-Esprit, Co.Montcalm, authorized assignor, and Claude Perras, trustee.NOTICE OF SALE Public notice is by these presents given that the following immoveables, to wit: Description \"1.All the rights, parts and pretentions which he has or may have on wood lots, situated in the parish of St-Calixte, known on the official plan and in the book of reference of the cadaster for the township of Kilkenny, as forming part of lots numbers 6 B, six C, six D, and six E in the third range, bounded at both ends by the \"cordons\", and on both sides by the purchaser.2.All rights, parts or pretentions which he has or may have in and on the two lots of land situated in the parish of St-Calixte, known and designated under numbers 4A and 4B of the seventh range of the township of Kilkenny, ac- 1682 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1968, Tome 90, N918 livre de renvoi officiels du cadastre de partie dudit canton, sans bâtisse.3° Un lot à bois situé à St-Calixte, contenant un arpent de front par vingt-huit arpent, borné dans les bouts par les cordons d'un côté à A.Beaudoin, de l'autre côté à T.Desroches, situé dans le troisième rang, partie du canton Kilkenny, connu sur le plan et au livre de renvoi officiels de partie du canton de Kilkenny, paroisse de St-Calixte, sous le numéro six-A, (6A).4e Un lot à bpis situé à St-Calixte.dans le Sième rang de Kilkenny, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de St-Calixte, canton de Kilkenny, sous le numéro six-G (6-G)\".Seront vendus comme une seule et même exploitation à la porte de l'église paroissiale de St-Calixte de Kilkenny, comté de Montcalm à ONZE heures de l'avant-midi heure avancée de l'est, MARDI le TROISIÈME jour de JUIN 1958.Cette vente est faite en vertu d'un jugement rendu par la Cour Supérieure à Joliette le 3 mars 1958, et suivant les dispositions des articles 55 et suivants de la Loi de 1949 sur la faillite, afin de donner à cette vente l'effet du décret aux termes du Code de procédure civile.Conditions: comptant._ En plus du prix d'acquisition, l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement 2]^% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges s'adresser au soussigné.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 1958.Le Syndic, CLAUDE PERRAS.Bureau de: PERRAS & RAIN VILLE, Syndics, 4 est rue Notre-Dame, Montréal.47642-17-2-o Province de Québec, district de Joliette, Cour Supérieure, N° 631 (1956) \"En faillite\" Dans l'affaire de la faillite de: Léonard Grégoire, industriel, St-Esprit, comté de Montcalm cédant autorisée; et Claude Perras, syndic.AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que les immeubles suivants seront vendus comme un seul lot, savoir: Désignation 1.Une terre à bois, située dans la paroisse de St-Esprit, comté de Montcalm, contenant vingt-cinq arpents, huit perches, connue aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Esprit, sous le numéro quatre cent soixante et douze (472), avec les bâtisses y érigées; ainsi que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes y attachées.2.Une terre â bois située en ladite paroisse de St-Esprit, connue et désignée comme faisant partie du lot numéro cinquante-trois (P.N° 53) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de ladite paroisse, contenant environ un arpent et demi de largeur sur douze arpentsde profondeur, plus ou moins, et bornée du côté nord par M.Albert Lapierre, du côté sud par un fossé séparant le terrain présentement vendu de celui de M.cording to the official plan and in the book of reference of the cadaster of part of the said township, without building.3.A wood lot situated at St-Calixte, containing an arpent in frontage by twenty-eight arpents, bounded at the ends by the \"cordons\" on one side to A.Beaudoin, on the other side, by T.Desroches, situated in the third range, partly by the township Kilkenny, known on the official plan and in.the book of reference of part of the township of Kilkenny, parish of' St-Calixte, under number six-A.(6A).4.A wood lot situated at St-Calixte, in the 3rd range of Kilkenny, known and designated on the official plan and in the book of reference of St-Calixte, township of Kilkenny, under number six-G (6-G).\" Shull be sold as a one and only concern at the paiochial church door of St-Calixte de Kilkenny, county of Montcalm, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Eastern Daylight Saving Time, TUESDAY, the THIRD day of June, 1958.This sale is made by virtue of a judgment rendered by the Superior Court at Montreal, March 3.1958, and following the provisions of section 55 and following of the bankruptcy Act of 1949, so as to give to this sale the effect of a Sheriff's sale according to the terms of the Code of Civil Procedure.Conditions: Cash.Over and above the purchase price, the purchaser, must pay Government rights of 2>£% in conformity with the law.For other information and list charges, apply to the undersigned.' Dated at Montreal, this seventeenth day of April; 1958.CLAUDE PERRAS.| Trustee, j Office of: PERRAS & RAIN VILLE, Trustees, 4 Notre-Dame St., east, Montreal, P.Q.47642-17-2 Province of Quebec, district of Joliette, Superior Court.No.631 (1956) \"In bankruptcy\".In the matter of the bankruptcy of Léonard Grégoire, industrialist, St-Esprit, Co.Montcalm, authorized assignor, and Claude Perras,' trustee.NOTICE OF SALE Public notice is by these presents given that the following immoveables, shall be sold as a one and only lot, to wit: Designation i 1.A wooded land, situated in the parish of St-Esprit, county of Montcalm, containing twenty-five arpents, eight rods, known on the official plan and in the book of reference of the cadaster of the parish of St-Esprit, under number four hundred and seventy-two (472), with buildings thereon erected; as the whole is to be found presently with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached thereto.2.A wooded land situated in the said parish of St-Esprit, known and designated as forming part of lot number fifty-three (Pt.No.53) on the official plan and in the book of reference for the cadaster of the said parish, containing an arpent and onehalf in width by twelve arpents in depth, more or less, and bounded on the North side by Mr.Albert Lapierre, on the South side, by a ditch separating the land at present sold from QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE; Quebec, May 8rd, 1968, Vol.90, No.18 1683 Florian Bleau, du côté ouest par M.Adolphe that of Mr.Florian Bleau, on the West side, by Lafortune, et de l'autre côté, à l'est par M.Jo- Mr.Adolphe Lafortune, and on the other side,-seph Du gas, avec les bâtisses y érigées; on the East, by Mr.Joseph Dugas, with the build ings thereon erected.Sera vendu à la porte de l'église paroissiale de Shall be sold at the parochial church door of St-Esprit, ccmté de Mcntc aim, à MIDI, heure St-Esprit, county of Montcalm, at NOON, avancée de l'est JEUDI le VINGT-NEUF de Eastern Daylight Saving Time, THURSDAY, MAI im.MAY TWENTY-NINE, 1968.Cette vente est faite en vertu d'un jugement This sale is made by virtue of a judgment rendu, par la Cour Supérieure à Joliette.le 3 rendered by the Superior Court at Joliette, mars 1968, et suivant les dispositions des articles March 3, 1968, and following the provisions of 65 et suivants de la Loi de 1949 sur la faillite afin section 55 and following of the Bankruptcy Act de donner A cette vente l'effet du décret aux ter- of 1949, so as to give to this sale the effect of a mes du Code de procédure civile.Sheriff's sale according to the terms of the Code of Civil Procedure.Conditions: comptant.Conditions: Cash.En plu s du prix d'achat l'acquéreur devra payer Over and above the purchase price, the pur» les droits du Gouvernement de 2J^% conformé- chaser must pay Government rights of 2%% in ment à la Loi.conformity with the law.Pour ai.tres renseignements et cahier des char- For other information and list charges, apply ges s'adiesser au scussigné.to the undersigned.Daté à Montréal, ce 17e jour d'avril 1958.Dated at Montreal, this seventeenth day of April, 1958.Le Syndic, CLAUDE PERRAS, Bureau de CLAUDE PERRAS.Office of: Trustee.PERRAS & RAINVILLE, Syndics, PERRAS & RAINVILLE, Trustees, 4 est rue Notre-Dame, 4, Notre-Dame St., East, Montréal, P.Q.47643-17-2-0 Montreal, P.Q.47643-17-2 Vente par licitation Sale by Licitation r Canada, Province de Québec, district de Trois- Canada, Province of Quebec, District of Trois-Rivièies, Cour Supérieure, N° 19-105, Armand Rivières, Superior Court, No.19-105, Armand Gauthier, journalier, des cité et district de Trois- Gauthier, laborer, of the city and district of Rivières, demandeur: vs Raoul Gauthier, Alice Trois-Rivières, plaintiff, vs Raoul Gauthier, Ali-Gauthier, Philippe Livernoche, en sa qualité de ce Gauthier, Philippe Livernoche, in his quality curateur à sa fille Claudette, mineure émancipée, of Curator for his daughter, Claudette, of full Roger Liverncche, René Livernoche, Je an-Roc h age, Rcger Livernoche, René Livernoche, Jean-Livernoche, tous des cité et district de Trois- Roch Livernoche, all of the city and district of Rivières; Alphonsine Gauthier, épouse commu- Trois-Rivières; Alphcnsine Gauthier, wife cornue en biens de Jack Flansberry avec qui elle de- mon as to property of Jack Flansberry with meure en les cité et district de Montréal, et ce whem she lives in the city and district of Mont-dernier-pour autoriser son épouse, et Dolores real, and the latter to authorize his wife, and Livernoche, épouse séparée de.biens de Joseph Dolores Livernoche, wife separate as to property E.DiBertolo avec qui elle demeure à Philadel- of Joseph E.DiBertolo, with whom she lives at phie, États-Unis d'Amérique, et ce dernier pour Philadelphia, the United States of America, and autoriser son épouse en autant que besoin est, the latter to authorize his wife inasmuch as is défendeurs.necessary, defendants.AVIS DE LICITATION NOTICE OF LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de ^ Notice is hereby given that in virtue of ^ a la Cour Supérieure, siégeant à Trois-Rivières, judgment of the Superior Court, sitting at Trois-dans le district de Trois-Rivières, le 21 avril Rivières, in the district of Trois-Rivières, on 1958, dans la présente cause, ordonnant la lici- April 21, 1958, in the present case, ordering the tat ion de l'immeuble désigné comme suit, savoir: licitation of the immoveable designated as follows, wo wit: \"Un emplacement situé sur la rue St-Philippe, \"An emplacement situated on St-Philippe en la cité des Trois-Rivières connu et désigné Street, in the city of Trois-Rivières, known and sous le lot quatre cent quarante (440) aux plan designated under lot four hundred and forty et livre de renvoi officiels de la cité des Trois- (440) on the official plan and in the book of refe-Rivières, avec une maison à deux logements rence of the city of Trois-Rivières, with a two-portant les numéros civiques 2236 et 2238 de tenement house bearing civic numbers 2236 and ladite rue, circonstances et dépendances.\" 2238 of the said Street, circumstances and dependencies.\" L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'en- The immoveable above designated shall be chère et adjugé au plus offrant et dernier en- sold by auction and adjudged to the highest and chérisseur, le VINGT-SIXIÈME jour de JUIN last bidder on the TWENTY-SLXTH day of 1958, Cour tenante, dans la salle d'audience du JUNE, 1958, in open court, in the Court Room Palais de Justice de Trois-Rivières, sujet aux of the Court House of Trois-Rivières, subject charges, clauses et conditions indiquées dans le to the charges, clauses and conditions mentioned cahier des charges déposé au greffe du protono- in the List of Charges filed in the Office of the taire de ladite Cour; et que toute opposition à Protonotary of the said Court; and that any fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de dis- opposition to annul, to secure charges or to 1684 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 traire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Les Trois-Rivières, le 29 avril 1958.Le Procureur du demandeur, 47674-18-2-0 JACQUES LACOURSIÊRE.withdraw from the said licitation, must be filed in the of the Office of the Protonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and that any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; and in default by the interested parties to file the said opposition within the delays hereby prescribed, they shall be foreclosed from so doing.Trois-Rivières, April 29, 1958.JACQUES LACOURSIÊRE, 47674-18-2 Attorney for the plaintiff.Ventes pour taxes Sales for Taxes AVIS PUBLIC Avis est donnée par le soussigné secrétaire-trésorier de la ville de St-Pélicien.que le HUIT MAI mil neuf cent cinquante-huit, à NEUF heure de lavant-midi, en la salle de l'Hôtel de ville de St-Félicien, seront vendus à l'enchère les immeubles ou propriétées dont les taxes imposées n'ont pas été payées.Voici le détail de ces propriétés ou immeubles: ' Girard Edmourd, propriétaire lot 4-A-l, située sur la rue Buivin, du cadastre officiel du canton Desmeules pour taxes municipales: $268.05: taxes scolaires: 1254.20.Pot vin Roch.propriétaire lot 49A32, situé sur la rue St-Christophe, du 3ième rang, canton Ashuapmou'chouan pour taxes municipales: $228.-65; taxes scolaires: $265.40.Pot vin VVellic.propriétaire des lots N° 1A85 et l-A-96, coin Notre-Dame et rue Bouchard, 3ième rang du canton Ashuapmouchouan, pour taxes municipales: $171.75; taxes scolaires: $105.05.Roy Thomas Louis, propriétaire des lots 4-A-5, situé sur la Plateau Boivin.faisant parti du canton Desmeules, pour taxes municipales: $581.90; taxes scolaires: $224.70.Numéro civique 6-8-10-12.Tremblay Leopold, fils Edm.-Ls., propriétaire des lots 4-A-l6, situé sur le Blvd Projeté et la rivière Eusèhe partie du canton Desmeules, pour taxes municipales: $9.85; taxes scolaires: $12.25.Donné sous mon sein, à St-Félicien le vingt-trois avril mil neuf cent cinquante-huit.47668-18-2-o Le Secrétaire-trésorier, J.A.BLOUIN.Province de Québec PUBLICJJOTICE Public notice is given by the undersigned Secretary-Treasurer of the town of St.Félicien, that the EIGHTH day of MAY, one thousand nine hundred and fifty-eight, at NINE o'clock in the forenoon, in the Hall of the City Hall of St.Félicien, shall he sold by auction the immoveables or properties fro the unpaid taxes imposed thereon.Herewith are details concerning said properties or immoveables: Girard Edmourd, owner of lot 4-A-l situate on Boivin Street, of the official cadastre of the township of Desmeules, for: municipal taxes; $268.05: school taxes: $254.20.Potvin Roch, owner of lot 49A32, situated on St.Christophe Street, range 3.township of Ashuapmouchouan for: municipal taxes: $228.65; school taxes: $265.40.Potvin Wellie.owner of lots No.1A85 and l-A-96, corner of Notre Dame and Bouchard Street, range 3, township of Ashuapmouchouan for: municipal taxes: $171.75; school taxes: $105.05.Roy Thomas Louis, owner of lots 4-A-5, situated on Boivin Plateau, forming part of the township of Desmeules for: municipal taxes: $581.90: school taxes: $224.70.Civic number 6-8-10-12.Tremblay Leopold, son Edm.Ls., owner of lots 4-A-16, situated on the proposed Blvd and Eusèbe River, part of the township of Des-meules for: municipal taxes: $9.85; school taxes: $12.25.Given under my seal, at St.Félicien the twenty-third day of April* one thousand nine hundred and fifty-eight.J.A.BLOUIN, 47668-18-2 _Secretary-Treasurer.Province of Quebec Municipalité du comté de Mégantic Municipality of the County of Meoantic Avis public est par le présent donné par Edouard Houde, secrétaire-trésorier que les terrains ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique dans le village d'Inverness, au lieu où le conseil de comté tient ses sessions, MERCREDI, le ONZE JUIN 1958 à DIX heures du matin, tel que fixé par règlement, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.Public notice is hereby given by Edouard Houde, secretary-treasurer that the undermentioned lands will be sold at public auction, in the village of Inverness, at the place where the county council holds its sittings, on WEDNESDAY the ELEVENTH of JUNE 1958 at TEN o'clock a.m.as enacted by a by-law, in default of payment of taxes due thereon and costs incured.Municipalités Municipalities\tCantons Townships\tAppartenant à Owned by\tRangs Ranges\tLots\tEten.Surf.\tTaxes \tStanfold____\t\t\tP-5 & P-6\t\t* 88.50 72.43 115.37 \t\tLeopold Bélanger.Leopold Bélanger.\t8.\t457 & 458.P.S.E.459.\t70 ac.70 ao.\t \t\t\t8.\t\t\t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1958, Vol.90, No.18 1685 Municipalité du village de Bernierville Le lot 337-21 du cadastre officiel revisé de la Croisse de St-Ferdinand, canton d'Halifax, pour municipalité du village de Bernierville de 75 pieds de largeur par 100 pieds de profondeur.Connu comme appartenant à Georges-Albert Houde.Taxes dues: $186.24.Municipalité de la paroisse de St-Pierre-Baptiste Un'morceau de terrain contenant 300 pieds de front sur 100 pieds de profondeur, mesure française, borné en avant, sur le front, à la route et des autres côtés à Onésime Dubois, connu au cadastre du premier rang du canton d'Inverness comme étant partie No 56, circonstances et dépendances.Connu comme appartenant à Irenée Payeur.Taxes dues: $12.85.Municipalité d'Irlande Sud Le lot 196-5 et la demie nord-est du lot 196-7 du rang 3 du canton d'Irlande, bornée au nord-est à la rivière Bécancour et au lot 196-5, au sud-est par le lot 197-1, au sud-ouest par une partie du lot 196-7 et au nord-ouest par le lot 196-6, sujets lesdits lots au billet de location et à la servitude de Lake Asbestos of Quebec Limited, enregistrée sous le numéro 29806.Connu comme appartenant à Robert Turcotte.Taxes dues: $64.25.Municipalité d'Irlande Sud La partie sud-est du lot 62, rang 1 du canton d'Irlande, contenant 50 acres, plus ou moins, bornée au sud-est par le lot 63, à un bout par partie du lot 81, de Vautre côté au nord-ouest par le résidu du lot 62 et à l'autre bout par le canton de Wolf es town, avec circonstances et dépendances et les servitudes y attachées.Le lot 63 du rang 1 du canton d'Irlande, moins la partie vendue par Benoit Labonté à Lake Asbestos of Quebec Limited le 18 juin 1956, par acte enregistré sous le numéro 33035.Le lot 64 du rang 1 du canton d'Irlande, moins la partie vendue par Benoit Labonté à Lake Asbestos of Quebec Limited le 18 juin 1956, par acte enregistré sous le numéro 33035.Le lot 64 est sujet à une servitude consentie en faveur de Lake Asbestos of Quebec Limited, par acte du 14 février 1957 enregistré sous le numéro 34382.Connu comme appartenant à Benoît Labonté.Taxes dues: $94.10.Plessisville, le 30 avril 1958.Le Secrétaire-trésorier de la Corporation du comté de Mégantic, 47691-18-2-0 EDOUARD HOUDE.Municipality of the village of Bernierville Lot 337-21 of the official cadaster revised, for the parish of St.Ferdinand, township of Halifax, for the municipality of the village of Bernierville, having 75 feet in width by 100 feet of depth.Known to be owned by Georges Albert Houde.Taxes due: $186.24.Municipality of the parish of St.Pierre-Baptiste A piece of land containing 300 feet in front by 100 feet of depth, french measure, bounded in front, by the byroad and the other side by Onésime Dubois, known to the cadaster of the first range of the township of- Inverness has being part of lot No.56, circumstances and dependencies.Known to be owned by Irenée Payeur.Taxes due: $12.85.Municipality of Ireland South Lot 196-5 and the northeast half of lot 196-7 of range 3 of the township of Irelmd, bounded at the northeast by the Becancour river and by lot 196-5.at the southeast by lot 197-1, at the southwest by a part of lot 196-7 and at the northwest by lot 196-6, both lots subject to a note of location and to the servitude m favour of Lake Asbestos of Quebec Limited, registered under No.29806.Known to be owned by Robert Turcotte.Taxes due: $64.25.Municipality of Ireland South The Southeast part of lot 62 of range 1 of the township of Ireland, containing 50 acres, more or less, bounded at the southeast by lot 63, at one end by part of lot 81, on the other side at the northwest by the balance of lot 62 and at the other end by the township of Wolfestown, circumstances and dependencies and the servitudes attached.Lot 63, range 1 of the township of Ireland, less the part sold by Benoit Labonté to Lake Asbestos of Quebec Limited on June the 18th 1956, by deed registered under number 33035.Lot 64, range 1 of the township of Ireland, less the part sold by Benoit Labonté to Lake Asbestos of Quebec Limited on June the 18th 1956, by deed registered under number 33035.Lot 64 is subject to a servitude granted in favour of Lake Asbestos of Quebec Limited, by deep of February the 14th 1957 registered under number 34382.Known to be owned by Benoit Labonté.Taxes due: $94.10.Plessisville, April 30th, 1958.EDOUARD HOUDE, -Secretary-Treasurer of the Corporation of 47691-18-2-o the county of Megantic.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Province de Québec District d'Abitibi Cour Supérieure, / pAUL BEAUDOLN, opéra-Ne V-3507.< * teur de moulin à scie de IPreissac, district d'Abitibi, SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.' ABITIBI Province of Quebec District of Abitibi Superior Court, / \"HAUL BEAUDOLN, saw-mill No.V-3507.< -t operator of Preissac, dis-Itrict of Abitibi, plaintiff, vs 1686 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mai 1958, Tome 90, N° 18 demandeur vs RAOUL ST-ÏULIEN, homme RAOUL ST-JULIEN, business man of Val d'affaires de Val d'Or, district d'Abitibi, défen- d'Or, district of Abitibi, defendant deur.AVIS DE VENTE Les immeubles connus et désignés comme étant les lots numéros 653 et 654 du cadastre officiel pour le canton Bourlamaque et le lot numéro 00-113 rang 8 du cadastre officiel pour le canton Dubuisson.avec bAtisse dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu A lu |»orte de l'église paroissiale St-Sniiveur de Val d'Or, le QUATORZIÈ-M E jour de MAI 195&à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi.-Bureau du Shérif.J.A.GAUTHIER.Aiuim, 5 avril 1958.47513-15 L' o NOTICE OF SALE The immoveables known and designated as being lots numbers 653 and 654 of the official cadaster for the township of Bonrlamaqtie and lot number 00-113 range 8 of the official cadaster for the township of Dubuisson, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To l>e sold at the parochial church door of St-Sauveur «f Val d'Or, on the FOURTEENTH day of MAY, 1958, at THREE o'clock in Ike afternoon.J.A.GAUTHIER.Sheri.T's Office.Sheri.F of A bit ibi.Amos, April 5.1958.47513-15-2 Province de Québec Distrw t d'Abitibi Cour de l'Échiquier / T\"\\ans l'affaire de la LOI du Canada, ) ^ DE L'IMPÔT SUR N° 142,062.) LE REVENU et amen-' dements et dans l'affaire de ROGER LACHAPELLE, de la ville de Val d'Or, P.Q.AVIS DE VENTE Les immeubles connus et désignés comme étant les lots numéros 61 subdivision 96 (partie) et 97 (partie) du rang 8 du canton Dubuisson tels que décrits aux plan et livre de renvoi officiels pour la ville de Val d'Or, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale Notre-Dame de Fatima, le QUATORZIÈME jour de MAI 1958 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 5 avril 1958.47514-15-2-o Province of Quebec District of Abitibi Exchequer Court / Tn the matter of the of Canada, ) 1 INCOME TAX ACT No.142,062.j and amendments and in fthe matter of ROGER LACHAPELLE, of the town of Val d'Or, P.Q.NOTICE OF SALE The immoveables known and designated as being lots numbers 61 subdivision 96 (Part) and 97 (Part of range 8 of the township of Dubuisson as described on the official plan and in the book of reference for the town of Val d'Or, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Notre-Dame of Fatima, on the FOURTEENTH day of MAY, 1958 at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, April 5, 1958.47514-15-2 Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour de Magistrat, / A MOS LUMBERTLIM-N° 14,598.< -Hl ITED, corps politi-v que et incorporé, ayant une place d'affaires à Amos, district d'Abitibi, demanderesse-saisissante; vs QUEBEC BERYLLIUM LIMITED, corps politique et incorporé, ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, défenderesse-saisie.AVIS DE VENTE L'immeuble connu et désigné com-me étant: Une bâtisse de 30 pieds de longueur et 6 pieds de largeur; une bâtisse de 15 pieds de longueur et 10 pieds de largeur en bois non peinturée, couverture verte; le tout situé à environ 12 milles d'Amos, sur la route Amos \u2014 La Motte.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Mathieu, le QUATRIÈME jour de JUIN 1958 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 22 avril 1958.47669-18-2-o Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Magistrate's Court, ( A MOS LUMBER LIM- No.14,598.< -f* ITED, a body poli-l tic and incorporated, having its head office at Montreal, district of Montreal, plaintiff-distrainer; vs QUEBEC BERYLLIUM LIMITED, a body politic and incorporated, having its head office at Montreal, district of Montreal, defendant seized.NOTICE OF SALE The immoveable known and designated as being: A building of 30 feet in length and 6 feet in width; a building of 15 feet in length and 10 feet in width in unpaintcd wood, green roof; the whole situated at about 12 miles from Amos, on the Amos road \u2014 La Motte.To be sold at the parochial church door of St-Mathieu, on the FOURTH day of JUNE, 1958, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, April 22, 1958.47669-18-2 Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour Supérieure, / \"DENOIT VEILLETTE, N° 11052. contremaître, domicilié à vNormétal, district d'Abitibi, Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Superior Court, /\"DENOIT VEILLETTE, No.11052.< \" foreman, domiciled at INormetal, district of Abitibi, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1687 demandeur; vs.ARISTIDE BOISVERT, autre- plaintiff; vs.ARISTIDE BOISVERT, formerly fois de La Sarre et maintenant domicilié à of La Sarre and presently domiciled at Chapleau, Chapleau, dans la province d'Ontario, défendeur, in the Province of Ontario, defendant.AVIS DE VENTE Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 164 du bloc 10 des plan et livre du cadastre officiel du village de La Sarre et les bâtisses dessus érigées circonstances et dépendances.Un immeuble connu et désigne comme étant le lot 163 du bloc 10 des plan et livre du cadastre officiel du village .de La Sarre et-4es bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Distraction d'un emplacement de 25 pieds de largeur par 17 pieds de profondeur à la partie sud-est du lot 163, bloc 10.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de La Sarre, ce QUATRIÈME jour de JUIN 1958 à DEUX heures de l'aprVmidi.Le Shérif d'AbiMbi, Bureau du Shérif.J.A.GAUTHIER.Amos, 24 aviil 1958.47670-18-2-o ARTHABASKA - Fieri Facias de Bonis et de Terris District d'Arthabaska Cour Supérieure, / t ES RELIGIEUSES HOS- N° 12 761.PITALIÊRES ST- (JOSEPH, corporation légalement constituée, ayant son siège d'affaires à Arthabaska, demanderesses; vs GEORGES NAULT, du district d'Arthabaska, domicilié à Tingwick, défendeur.Une terre {tant la moitié nord-est du lot numéro vingt-quatre du quatrième rang du canton de Tingwick, mesurant cent-dix-huit acres en superficie, plus ou moins, avec maison et autres bâtisses dessus construites, connue et désignée au cadastre officiel du canton de Tingwick comme étant le numéro trois cent quatre-vingt-dix-sept.Pour être vendue à la porte de l'cglise paroissiale de St-Patrice de Tingwick lé CINQUIÈME jour de JUIN 1958 à TROIS heures de l'après-midi.(Heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FÉLIX HOULE.Arthabaska, ce 30 avril 1958.47690-18-2-o BEAUHARNOIS Fieri Fadas de Terris Cour Supérieure, {/\"GEORGES ANDRÉ ME-N° 3362.< *J LOCHE, avocat, de la (cité de Salaberry de Valley-field, district de Beauharnois, demandeur; vs JEAN SÉNÊCAL, de la cité de Salaberry de Valleyfield, district.de Beauharnois, défendeur.A savoir: \"Les lots numéros deux cent huit, deux cent neuf et deux cent dix (Nos 208, 209, et 210), des plan et livre de renvoi officiels de la la ville de Salaberry de Valleyfield, sans bâtisse.\" Pour être vendu au Bureau du Shérif, Palais de Justice, à Salaberry de Valleyfield, JEUDI le CINQUIÈME jour de JUIN 1958, à \"DIX heures de l'avant-midi.Salaberry de Valleyfield, ce vingt-cinquième jour d'avril 1958.Le Shérif de Beauharnois, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.47671-18-2-o [Première publication le 3 mai 1958] NOTICE OF SALE An immoveable known and designated as being lot 164 of block 10 of the plan and book of reference of the official cadastre of the village of La Sarre and the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.An immoveable known and designated as being lot 163 of block 10, of the plan and hook of references of the official cadastre of.the village of La Sarre and buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Excluding an emplacement of 25 feet wide by 17 feet deep at the southeasterly part of lot 163, block 10.To be sold at the door of the parochial church of La Sarre on the FOURTH day of JUNE 1958, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, SheriT's Office, Sheriff of AbiMbi.Amos, April 24, 1958.47670-18-2 ARTHABASKA \u2022 Fieri Facia* de Bonis et de Terris District of Arthabaska Superior Court, / t ES RELIGIEUSES HOS-No.12 761.PITALIÊRES ST- ( JOSEPH, corporation legally constituted, having its head office at Arthabaska, plaintiff; vs GEORGES NAULT, of the district of Arthabaska, domiciled at Tingwick, defendant.A farm being the northeasterly half of lot number twenty-four, range four of the township of Tingwick, measuring one hundred and eighteen acres in area, more or less, with house and other buildings thereon erected, known and designated on the official cadastre of the township of Tingwick as being number three hundred and ninety-seven.- N To be sold at the door of the parochial church of St.Patrice de Tingwick, the FIFTH day of JUNE 1958, at THREE o'clock in the afternoon.(Daylight Saving Time).FÉLIX HOULE, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, this April 30, 1958.47690-18-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias de Terris Superior Court, ( /GEORGES ANDRÉ ME-No.3362.< VJ LOCHE, advocate, of (the city of Salaberry de Valleyfield, district of Beauharnois, plaintiff; vs JEAN SÉNÊCAL, of the city of Salaberry of Valleyfield, district of Beauharnois, defendant.To wit: \"Lots numbers two hundred and eight, two hundred and nine and two hundred and ten (Nos.208, 209 and 210) on the official plan and in the book of reference for the town of Salaberry of Valleyfield, without building.\" To be sold at the Sheriff's Office, Court House, at Salaberry de Valleyfield, THURSDAY, the FIFTH day of JUNE, 1958, at TEN o'clock in the forenoon.Salaberry of Valleyfield, this twenty-fifth day of April, 1958.ERNEST POIRIER, Sheriff's Office, Sheriff of Beauharnois.47671-18-2 [First publication May 3, 19581 1688 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 mai 1968, Tome 90, N* 18 CHICOUTIMI Canada \u2014 Province de Québec District de Saint-François Cour Supérieure,/INTERNATIONAL CASH N° 17,160.< I REGISTER INC., corps (politique incorporé ayant siège social et bureau d'affaires à Sherbrooke, district de St-François, demanderesse; vs PAUL MORRIER, domicilié au numéro 1015 de la rue Mélançon.en la cité de Chicoutimi, district de Chicoutimi, défendeur.Contre le défendeur: Le lot numéro soixante-huit-vingt-vingt-sept (68-20-27) du premier (1er) rang nord-est du chemin Sydenham, au plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Chicoutimi.avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau du shérif, au palais de justice, en la cité de Chicoutimi, district de Chicoutimi, le CINQUIÈME jour du mois de JUIN 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi, le 28 avril 1958.47686-18-2-o GASPÉ Fieri Facias de Terris District de Gaspé Cour Supérieure, / /GIRARD SALES LTD., & N° 4988.{ vJ CORMICK KENNE-(DY, Douglastown, -comté de Gaspé requérant: contre LES HÉRITIERS LÉGAUX DE NORMAN FORTIN, Douglastown, comté de Gaspé.intimés.La propriété à vendre est la suivante: Une certaine parcelle ou lopin de terrain formant partie du lot N° seize-A (16-A) du premier rang Bois Brûlé, mesurant deux acres de largeur par quinze acres de profondeur, plus ou moins et borné au nord par la propriété de Gilbert Briand.au sud par le chemin Broad, à l'est par le chemin N° 6 et à l'ouest par la ligne de base.Une certaine parcelle ou lopin de terrain formant partie du lot N° vingt et un (21) du cinquième rang de \"Bois Brûlé, canton de Douglas, borné au nord par la propriété de Thomas Gaul, au sud par la ligne de base, à l'est par la propriété de Gerald Brody et à l'ouest par celle d'Orner Maloney, avec les bâtisses érigées sur les deux parcelles de terrain, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de Douglastown, MARDI le TROISIÈME jour de JUIN 1958, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., 28 avril 1958.47687-18-2-o HULL Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure, fPHE J.R.WATKXNS N° 4207.< a COMPANY, un corps (politique et incorporé ayant son siège social et principal place d'affaires à Winona, dans l'État de Minnesota, un des États Unis d'Amérique, et ayant une place d'affaires en les cité et district de Montréal, demanderesse; vs FRED CHARLEBOIS, de Cantley, district de Hull et ROGER CHEVPJER, de Limbour, district de Hull, défendeurs.CHICOUTIMI Canada \u2014 Province of Quebec District of Saint Francis Superior Court, ( INTERNATIONAL CASH No.17,150.< a REGISTER INC., body (politic and corporate having its head office and place of business at Sherbrooke, district of St.Francis, plaintiff; vs PAUL MORRIER, domiciled at number 1015 M-lançon Street, in the city of Chicoutimi, district of Chicoutimi, defendant.Against the defendant: Lot number sixty-eight-twenty-twenty-seven (68-20-27) of range one (1st.) northeast of Sydenham Road, of the plan and book of reference of the official cadastre of the parish of Chicoutimi, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the office of the Sheri?, at the Court House, in the city of Chicou'imi, district of Chicoutimi, the FIFTH day of the month of JUNE 1958, at THREE o'clock in the afternoon.RENE DELISLE, Sheri 7's Office, Sheriff.Chicoutimi, April 28, 1958.47686-18-2 GASPÉ Fieri Facias de Terris District of Gaspé Superior Court, /OIRARD SALES LTD., & No.4988.< CORMICK KENNE-(DY.Douglastown.county of Gaspé.plaintiffs: vs THE LEGAL HEIRS OF THE LATE NORMAN FORTIN, county of Gaspé, respondents.The property to he sold is the following: A certain piece of tract of land forming part of lot No.six teen-A (16-A) of the first range Bois Brûlé, measuring two acres in width by fifteen acres in depth, more or less and bounded on the North by Gilbert Briand.on the South Broad Road, on the East by Highway No.6, and on the West by base line.A certain parcel or tract of land forming part of lot No.twenty-one (21) of the fifth range Bois Brûlé, township of Douglas, bounded on the North by Thomas Gaul, on, the South by.base line, on the East by Gerald Brody and on the West by Omer Maloney, with buildings erected on both parcels of land, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Douglastown, TUESDAY, the THIRD day, JUNE at TEN o'clock in the forenoon.J.F.MEAGHER, Sheriffs Office, Sheriff.Percé, P.Q.April 28, 1958.47687-18-2 HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, /THE'J.R.WATKINS No.4207.< a COMPANY, a body po-(litic and corporate having its Head Office and principal place of business in Winona, in the State of Minnesota, one of the United-States of America, and having a place of business in the city and district of Montreal, plaintiff; vs FRED CHARLEBOIS of Cantley, in the district of Hull, and ROGER CHEVRIER, of Limbour, in the district of Hull, defendants. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 3rd, 1968, Vol.90, No.18 1689 \"Un immeuble sis dans le canton de Hull, \"An immoveable situate in the township of comté de Gatineau, province de Québec, appar- Hull, county of Gatineau, Province of Quebec, tenant au défendeur Roger Chevrier et consis- belonging to the defendant Roger Chevrier and tant en toute cette propriété connue et désignée consisting of the whole of that property known comme étant formée d'une partie du lot sept and designated as being formed of a part of lot (ptie.7) dans le neuvième rang dudit canton seven (P.7) in range nine of said township on aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton the official plan and book of reference of said et ledit emplacement mesurant cinquante pieds township, the said emplacement measuring fifty (50') de largeur ayant front sur le chemin public feet (50') in width with frontage on the public sur cent quarante pieds (140') de profondeur, highway by one hundred and forty feet (1400 mesures anglaises, et plus ou moins et bornée of depth, English measure, and more or less, au nord par une autre partie du même lot pro- bounded northerly by another part of the same priété.de Daniel Avon et tel qu'acquise par ce lot, the property of Daniel Avon, as acquired dernier aux termes d'un contrat exécuté devant by the latter in the terms of a contrat concluded Me Henri DesRosiers, nctaire, sous le numéro before Me Henri DesRosiere, notary, bearing 39871 de ses minutes dont copie enregistrée au number 39871 of his minutes, copy of which is bureau d'enregistrement de Gatineau, à Mani- registered in the Registry Office of Gatineau, at waki, sous le numéro 23732; au sud par line Maniwaki, under number 23732; southerly by autre partie du nn me lot étant la propriété de another part of the same lot, the property of Madame John A.Barber acquise par cette der- Mrs.John A.Barber, acquired by the latter in ni ère aux termes d'un contrat exécuté devant the terms of a contract concluded before the le notaire soussigné, sous le numéro 1405 de ses undersigned notary, bearing number 1405 of his minutes dont copie enregistrée audit bureau de minutes, copy of which is registered in said la division d'enregistrement de Gatineau, à Ma- Registry Division of Gatineau, at Maniwaki, niwaki, sous le numéro 25504; à l'ouest par une under number 25504; westerly by another part autre partie du même lot propriété du Collège of the same lot, the property of College Aposto-Apostolique St.Alexandre de la Gatineau, ou lique St.Alexandre de la Gatineau, or its suc-ses ayants droits, et à l'est par le chemin public; cessors, and easterly by the public highway; the les lignes nord et sud de l'emplacement présen- north and south lines of the emplacement pre-tement vendu étant approximativement à angle sently sold being approximately at right angles droit avec les lignes est et ouest dudit emplace- to the east and west lines of said emplacement; ment; la limite sud dudit emplacement étant the southerly boundary of said emplacement approximativement parallèle et à cent quatre- being approximately parallel to and at one vingt-dix pieds (1900 I'his ou moins au nord de hundred and ninety feet (1900 more or less north la ligne de division entre les rangs 8 et 9 dudit of the dividing line between ranges 8 and 9 of canton.Ledit emplacement indiqué par un po- said township.The said emplacement indicat-teau planté à chaque coin et bien cennu des par- ed by a post set up at each corner and well ties aux présentes.Avec toutes les bâtisses des- known by the parties herein.With all build-sus érigées, circonstances et dépendances\".ings thereon erected, circumstances and depen- dencies\".Pour être vendu à la porte de l'église St.To be sold at the door of the church of St.Alexandre, âLimbour, district de Hi 11, le SIXIÊ- Alexandre, at Limbour, district of Hull, the ME, jour de JUIN 1958, à DEUX heures de SIXTH day of JUNE 1958, at TWO o'clock in l'après-midi.the afternoon.Le Shérif, R, ST.PD3RRE, Bureau du Shérif, R.ST.PIERRE.Sheriffs Office, Sheriff.Hull, te 28 avril 1958.47672-18-2-o Hull, April 28, 1958.47672-18-2 québec quebec Fieri Facias Fieri Facias Québec, à savoir: / t EMILE LAQUERRE, Quebec, to wit:/t EMILE LA GUERRE, N° t0,215.< j \u2022 marchand de St-Édouard, No.90,215.-j j \u2022 merchant of St-Edouard, (comté de Lotbinière, contre (county cf Lotbinière, against DAME THÉRÈSE LA VIGNE, épouse séparée DAME THÉRÈSE LA VIGNE, wife separate de biens de Paul Laçasse avec lequel elle demeure as to property cf Paul Laçasse, with whom she à Chicopee, Massachusetts, États-Unis d'Ame- resides at Chicopee, Massachusetts, United rique, et ce dernier pour autoriser son épouse States cf America, and the latter, to authorize aux fins des présentes.his wife for these present purposes.\"Une terre située en la paroisse de St-Janvier \"A farm, situated in the parish of St^Janvier de Joly, comté de Lotbinière, étant les lots primi- de Joly, county of Lotbinière, being the primitive tifs numéros quarante-cinq et quarante-six lots numbers forty-five and forty-six (Nos.45 (Nos 45 et 46).distraction faite de la partie and 46), exception made of that part occupied occupée par le chemin de fer, dans le troisième * by the railroad in the third range of the Seigniory rang de la Seigneurie de Lotbinière, correspon- of Lotbinière, corresponding to numbers three dant aux numéros trois cent quatre-vingt-huit, hundred and eighty-eight, three hundred and trois cent dix-sept \"A\", trois cent quatre-vingt- seventeen \"A\", three hundred and eighty-eight, huit, trois cent dix-sept \"B\", trois cent quatre- three hundred and seventeen \"B\", three hundred vingt-huit, trois cent dix-sept \"C\", trois cent and eighty-eight, three hundred an
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.