Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 mai 1958, samedi 10 (no 19)
[" Tomb 90, N° 19 1695 Vol.90, No.19 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (M Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Quebec, samedi 10 mai 1958 Quebec, Saturday, Mat 10th, 1958 AVIS AUX INTÉRESSÉS NOTICE TO INTERESTED PARTIES Réglementa Rules 1° Adresser toute correspondance à: PImpri- - 1.Address all communications to: The Queen's meur de la Reine, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When same is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé xhen die said advertising copy is to be published doit alors acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine will be suspended without further notice and qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute without prejudice as regards the rights of the somme versée en plus.Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank mandat de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Officiai Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1696 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not re-v ceived on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour First insertion: 15 cents per agate line, for each chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 version, (14 lines to the inch, namely 266 lines lignes par page, pour les deux versions).per page, for both versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate Subsequent insertions: 5 cents per agate line, pour chaque version.for each version.La matière tabulaire (listes de noms, de chif- Tabular matter (list of names, figures, etc.) at fres, etc.) est comptée double.double rate.Traduction: 50 cents des 100 mots.Translation: 50 cents per 100 words.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Single copies: 30 cents each.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Slips: $1.per dozen.Abonnement: $7 par année.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices ont la signification suivante: have the following meaning: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'or- The first figure refers to our document number; dre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette the second to that of the edition of the Gazette pour la première insertion; le troisième à celui for the first insertion; the third the number of du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie insertions, and the letter \"o\" signifies that the que la matière n'est ni de notre composition ni copy was neither our composition nor our trans- de notre traduction.Les avis publiés une seule lation.Notice published but once are followed fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre, only by our document number.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS, RÉDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502 \u2014 l-52-o 41502 \u2014 l-52-o Lettres patentes (P.G.11072-58) Agence d'Assurance Mercure Inc.Mercure Assurance Agency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des conpagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1958, constituant en corporation : André Mercure, courtier d'assurance agréé, Mme Camille Mercure, veuve, (née Paule Vigneau) administratrice et Mme Odile Mercure, épouse séparée de biens dudit André Mercure, secrétaire, tous de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers d'assurances, sous le nom de \"Agence d'Assurance Mercure Inc.\u2014 Mercure Assurance Agency Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hvacin-the.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1958.L'Assistant-procurcur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.Letters Patent (A.G.11072-58) Agence d'Assurance Mercure Inc.Mercure Assurance Agency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1958, incorporating: André Mercure, chartered insurance broker, Mrs.Camille Mercure, widow, (née Paule Vigneau), manageress and Mrs.Odile Mercure, wife separate as to property of the said André Mercure, secretary, all of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers under the name of \"Agence d'Assurance Mercure Inc.\u2014 Mercure Assurance Agency Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 4,000 common shares of $10 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10thJ968, Vol.90, No; 19 1WJ (P.G.10996-58) Amérivieion Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de là Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Marcel-G.Robitaille, Pierre Dansereau, de Montréal, et André Fabien, de Longueuil, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de films, oeuvres musicales ou théâtrales, textes d'émission ou autres travaux du même genre, sous le nom de \"Améri-vision Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions communes d'une valeur au pair de $10 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 720, rue de l'Église, Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10987-58) Argo Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corporation: Jack Lightstone, Marvin Riback, avocats, et Gerald Cooper, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Argo Investments Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de $10 'chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10383-58) Bersal Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1958, constituant en corporation: Nathan Le vit sky, avocat, Nicholas Vlahos, avocat, et Carol Jones, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de produits, articles et marchandises fabriqués en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et sous-produits, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et revues périodiques, travaux artistiques, produits chimiques et de beauté, produits de la terre, de la mer et de la forêt, sous le nom de \"Bersal Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actons privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.10996-58) Amérivision Inc.Notice is hereby given that under.Part I*of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Marcel-G.Robitaille, Pierre Dansereau, of Montreal, and André Fabien, of Longueuil, all advocates, for the following purposes : To carry on a business dealing in films, musical and theatrical works, texts for broadcasting or other work along the same lines, under the name of \"Amérivision Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and into 3,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 720 Church Street, Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 17697 ' Acting Deputy Attorney General.(A.G.10987-58) Argo Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Jack Lightstone, Marvin Riback, advocates, and Gerald Cooper, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Argo Investments Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47097-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10383-58) Bersal Ltd.Notice is hereby given that under Part.I.of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1958, incorporating: Nathan Levitsky, advocate, Nicholas Vlahos, barrister, and Carol Jones, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art, chemical and beauty products, land, sea and forest products, under the name of \"Bersal Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.- P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. r698 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 (P.G.10604-58) (A.G.10604-58) Romp ton Iron and Metal Inc.Bompton Iron and Metal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la -been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty- du vingt-six mars 1958, constituant en corpora- sixth day of March, 1958, incorporating: Con- tion: Conrad Shatner, de la ville de Hampstead, rad Shatner, of the town of Hampstead, Harry Harry Blank et Baruch Pollack, de Montréal, Blank and Baruch Pollack, of Montreal, all tous avocats, pour les objets suivants: advocates, for the following purpose: Fabriquer et faire le commerce de métaux et To manufacture and deal in metals and metal produits d'iceux, sous le nom de \"Brompton products, under the name of \"Brompton Iron Iron and Metal Inc.\", avec un capital total de and Metal Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divisé en 100 actions privilégiées d'une $20,000, divided into 100 preferred shares having valeur au pair de $100 chacune et 100 actions a par value of $100 each and into 100 common ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune, shares having a par value of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Bromp- The head office^ of the company will be at tonville, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10646-58) Caligiuri Construction Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1958, constituant en corporation: Joseph Caligiuri.entrepreneur en construction, Frank Caligiuri, retraité et Dominic Caligiuri, dessinateur de vêtements masculins, tous de Montréal, pour les objets suivants: ¦ Exercer le commerce comme entrepreneurs, constructeurs et couvreurs, sous le nom de \"Caligiuri Construction Company Limited\", avec un capital total de $100.000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montreal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1958.L'Assis tant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10951-58) ~ Cartier Gas Corporation La Corporation de Gaz Cartier .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mars 1958, constituant en corporation: Jacques de Billy, avocat et conseil en loi de la Reine, Micheline Marchand, Pauline Marcotte, Lucile Rioux, secrétaires, filles majeures, tous quatre de Québec, Gilles de Billy, Claude Gagnon, conseils en loi de la Reine et René-W.Dionne, tous trois avocats, de Sillery, pour les bojets suivants: Exercer aucun ou plusieurs des commerces qui consistent à prospecter, produire, négocier, transporter, emmagasiner, distribuer et fabriquer du pétrole, carbonne, huiles, gaz, minerais et autres substances minérales et leurs produits, sous-produits et dérivés, sous le nom de \"Cartier Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Cartier\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à chambre 430, 100 d'Youville, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.Bromptonville, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE.47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10646-58) \" ' Caligiuri Construction Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1958, incorporating: Joseph Caligiuri, building contractor, Frank Caligiuri, retired, and Dominic Caligiuri, men's clothing designer, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors, builders and roofers, under the name of \"Caligiuri Construction Company Limited\", with a total capital stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P, FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10951-58) Cartier Gas Corporation La Corporation de Gaz Cartier Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1958, incorporating: Jacques de Billy, advocate and Queen's Counsel, Micheline Marchand, Pauline Marcotte, Lucile Rioux, secretaries, spinsters, all four of Quebec, Gilles de Billy, Claude Gagnon, Queen's Counsel, and René-W.Dionne, all three advocates, of Sillery, for the following purposes: To carry on any one or more of the businesses of prospecting for, producing, dealing in, transporting, storing, distributing and manufacturing petroleum, carbon oils, gases, ores and other mineral substances, and the products, by-products or derivatives thereof, under the name of \"Cartier Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Cartier\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Room 430, 100 d'Youville, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol^W,No.l9 jl69ô (P.G.13670-57) Center Warehousing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1958, constituant en corporation: Marin Dion, avocat, d'Outremont, Jean-Cbarles Ménard, estimateur, et Hector Bergeron, garagiste, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des entrepôts; exercer le commerce du transport et de l'emballage de marchandises, sous le nom de \"Center Warehousing Ltd.\", avec un capital total de 135,000, divisé en 350 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur généra), le vingt-neuf mars 1958.L'Assistant-procurcur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10974-58) Château Country Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: William Tetley, avocat, de Ville Mont-Royal, Charles A.Phelan, Peter Robert David MacKell, avocats et Marguerite Gravel, secrétaire, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tenanciers d'hôtel, taverne, auberge, club et restaurant comme propriétaires et opérateurs, sous le nom de \"Château Country Club Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 15.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 250 actions privilégiées d une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Rose, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10960-58) Clarranald-Snowdon Corporation 1 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, Maxwell Shenker, avocats, John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour ies\"objets suivants: Transiger les affaires d'une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de Clanranald-Snowdon Corporation\", avec un capital total de $99,000, divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 96,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur généra), le vingt-cinq mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.13670-57) Center Warehousing Ltd._ Notice is hereby given that under Part I .qj.the Quebec Companies' Aci, letters patent have, been issued by the Lieutenant-Governor of the, Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1958, incorporating: Mann Dion, advocate, of Outremount, Jean-Charles Ménard, assessor, and Hector Bergeron, garage-keeper, of Montreal, for the following purposes: To operate warehouses; to carry on a business dealing in transportation and the packaging of merchandise, under the name of \"Center.Warehousing Ltd.\", with a total capital stock of $35.000, divided into 350 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10974-58) Château Country Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: William Tetley/advocate, of the Town of Mount Royal, Charles A.Phelan, Peter Robert David Mac-.Kell, advocates, and Marguerite Gravel, secretary, spinster of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel, tavern, public house, club and restaurant keepers as owners and operators, under the name of \"Château Country Club Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 15,000 common shares of a par value of $1 each and into 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sainte-Rose, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Genera), this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o - Acting Deputy Attorney Genera), (A.G.10960-58) Clanranald-Snowdon Corporation .Notice-is hereby given that under Part I\"of the Quebec Companies' Act, letters patent bave, been issued by the Lieutenant-Governor of thé\" Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1958, incorporating: Samuel Chait, Maxwell Shenker, advocates, John Hamilton, secretary, all three of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the Town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on business as a holding and investment corporation, under the name of \"Clan-ranald-Snowdon Corporation\", with a total capital stock of $99,000, divided into 3,000 common shares of a par value of $1 each and into 96,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. 1700 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N919 (P.g.10390-68) (A.G.10399-68) Clinique Médicale Ahuntsic Inc.Clinique Médicale Ahuntsic Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty- du vingt-six mars 1958, constituant en cropora- sixth day of March, 1958, incorporating: Léo taon: Léo Boyer, Maurice Bertrand, médecins, Boyer, Maurice Bertrand,, physicians, of Mont- de Montréal, et Ephraim Lebocuf, avocat et real, and Ephraim Leboeuf, advocate and Queen's conseil en loi de la Reine, de Ville Mont-Royal, Counsel, of the Town of Mount Royal, for the pour les objets suivants: following purposes : Établir et administrer une clinique médicale, To establish and manage a clinique, hospital, un hôpital, un centre de diagnostic et un dis- diagnostic centre and dispensary, under the name pensaire, sous le nom de \"Clinique Médicale of \"Clinique Médicale Ahuntsic Inc.\", with a Ahuntsic Inc.\", avec un capital total de $40,000, total capital of $40,000, divided into 10,000 divisé en 10,000 actions communes de $1 cha- common shares of $1 each and 300 preferred cune et en 300 actions privilégiées de $100 cha- shares of $100 each, cune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté dn bureau du Procureur général» le Dated at the office of the Attorney General, vingt-six mars 1958.this twenty-sixth day of March, 1958.L'Assistant-procurcur général suppléant, P.FRENETTE, 47607-o P.FRENETTE.47697 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10712-58) Conrad Joyal Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première .partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: J.-André Du rocher, notaire, Thérèse Bouchard, secrétaire, célibataire, et Gilles Landry, comptable, tous de Coaticook, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie et en chauffage; exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Conrad Joyal Ltée'*, avec un capital total de $40,000, divisé en 50 actions communes de $100 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune, v Le siège social de la compagne sera à 471, rue Brock, Drummondville, district judiciaire d'Ar-thaba&ka.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47607-o P.FRENETTE.(A.G.10712-58) Conrad Joyal Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: J.André Durocher, notary, Thérèse Bouchard, secretary unmarried, and Gilles Landry, accountant, all of Coaticook, for the following purposes: To carry on business as plumbing and heating contractors; carry on the business of an investment company, under the name of \"Conrad Joyal Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 50 common shares of $100 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 471 Brock Street, Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10067-68) (A.G.10967-68) Daily Realty Corp.Daily Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the nineteenth du dix-neuf mars 1968, constituant en corpora- day of March, 1958, incorporating: Abie A rick, tion: Abie Arick, négociant d'immeubles, Issie realtor, Issie Abrams, salesman, both of Mont- Abrams, vendeur, tous deux de Montréal et real, and Stanley Backman, merchant, of the Stanley Backman, marchand, de la ville de Town of Côte St.Luc, for the following purposes : Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme agents d'im- To carry on business as real estate agents, meubles, sous le nom de \"Daily Realty Corp.\", under the name of \"Daily Realty Corp.\", with avec un capital total de $10,000, divisé en 100 a total capital stock of $10,000, divided into actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 100 common shares of a-par value of $10 each chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur and into 900 preferred shares of a par value of au pair de $10 chacune.$10 each.Le siège social de la compagEie sera à Mont real, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, dix-neuf mars 1958.this nineteenth day of March, 1958.L*Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 47697 .P.FRENETTE.47697-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1701 (P.G.10909-58) * Dell Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1958, constituant en corporation: Edward Irving Auerback, avocat, Madeline Ferguson, Miriam Bernard, secrétaires, filles majeures, toutes trois de Montréal, et Mark Edmund Gordon, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: - Transiger les affaires d'une compagnie de portefeuille et placements, sous le nom de \"Dell Realties Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.47697 .P.FRENETTE.(P.G.11029-58) Deïmar Heating & Supplies Company Avis est domté qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1958, constituant en corporation : Joseph P.Miller, avocat, de Ville La-Salle, Isidore Buller, avocat, Lorraine Lalonde, secrétaire, fille majeure, et George Kournikakis, restaurateur, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'installations pour le chauffage et pour la cuisson, sous le nom de \"Delmar Heating & Supplies Company\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10948-58) Dominion Air-Conditioning Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mars 1958, constituant en corporation: Max Bernfeld, conseil en loi de la Reine, Edward H.Bernfeld et Jack B.Bob rove, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à installer, fournir le service et effectuer la vente de systèmes d'air climatisé, sous le nom de \"Dominion Air-Conditioning Company Limited\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mars 1958.(A.G.10909-58) Dell Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebep Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of she Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1958, incorporating: Edward Irving Auerback, advocate, Madeline Ferguson, Miriam Bernard, secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Montreal, and Mark Edmund Gordon, advocate, of West-mount, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"Dell Realties Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, dividen into 1,000 common shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11029-58) Delmar Heating & Supplies Company Notice is hereby given that under.Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1958, incorporating: Joseph P.Miller, advocate, of Ville LaSalle, Isidore Buller, advocate, Lorraine Lalonde, secretary, spinster, and George Kournikakis, restaurant keeper, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in heating systems and cooking systems, under the name of \"Del-mar Heating & Supplies Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common*- shares.of $1 each and into 30,-000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10948-58) Dominion Air-Conditioning Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of March, 1958, incorporating: Max Bernfeld, Queen's Counsel, Edward H.Bernfeld and Jack B.Bobrove, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of installation, service and sales of air conditioning equipment, under the name of \"Dominion Air-Conditioning Company Limited\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of March, 1958.P.FRENETTE.47697-o Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE. 1702 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N°19 (P.G.10817-68) École Centrale du Canada Inc.Central School of Canada Inc.\u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi, des compagnies de Québec, il a été accordé par le LieutenaEt-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1968, constituant en corporation: Roland Déry, professeur en électronique, de Laval-des-Rapides, Roland Sulla, professeur en électronique, et Robert-E.-Delmas Doussin, ingénieur civil, de Montréal, pour les objets suivants: Organiser et constituer des écoles pour y dispenser l'enseignement des sciences, des arts, des mathématiques, et plus spécialement l'enseignement technique, technologique, scientifique, industriel et commercial, sous le nom de \"École Centrale du Canada Inc.\u2014Central School of Canada Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune et en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 237, boulevard St-.Joseph, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-e P.FRENETTE.(P.G.10989-58) Elgood Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant, en corporation: Jack Light stone, Marvin Riback, avocats, et Gerald Cooper, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme agents d'immeubles, entrepreneurs, constructeurs et couvreurs; faire le commerce de charbon, bois, grains et machinerie, outillage, et ferronnerie, sous le nom de \"Elgood Realties Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10976-58) ' El-Lis Construction Co., Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1958, constituant en corporation: Joseph Roy Hoffman, avocat, Muriel Dyall, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal et Oscar Respitz, avocat, de Ville Mont-Royal, pour les objets suivants\": Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"El-Lis Construction Co., Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.10817-58) École Centrale du Canada Inc.Central School of Canada Inc.Notice is hereby given that under Part I of thé Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April 1968, incorporating: Roland Déry, professor in electronics, of Laval-des-RapideS, Roland Sulla, professor in electronics, and Ro-bert-E.Delmas Doussin, civil engineer, of Montreal, for the following purposes: To organize and set up schools for the teaching of sciences; arts, mathematics, and more particularly, technical, technological, scientific, industrial and commercial training, under the name of \"École Centrale du Canada Inc.\u2014 Central School of Canada Inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 3,000 preferred shares of $10 each and 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 237 St.Joseph Boulevard, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April, 1958.P.FRENETTB, 47697 Acting Deputy Attorney General (A.G.10989-58) \" Elgood Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Jack Lightstone, Marvin Riback, advocates, and Gerald Cooper, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate agents, contractors, builders and roofers; to deal in coal, wood, grain and machinery, equipment and hardware, under the name of \"Elgood Realties Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General (A.G.10976-58) El-Lis Construction Co., Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-fourth day of .March, 1958, incorporating: Joseph Roy Hoffman, advocate, Muriel Dyall, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and Oscar Respitz, advocate; of the town of Mount Royal, for the following purposses: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"El-Lis Construction Co., Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1703 (P.G.11142-68) Évaporateur Portneuf Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: Real Cossette, industriel, Mme Gisèle Quessy Cossette, ménagère, épouse séparée de biens dudit Réal Cossette, et dûment autorisée Car lui et Lauriette Veillette, secrétaire, tous de 'or t neuf -Station, pour les objets suivants: Exercer le commerce de produits laitiers, oeufs, farine et moulées, sous le nom de \"Évaporateur Portneuf Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Portneuf-Staticn, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.11073-58) Family Hostess Sales Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1958, constituant en corporation: Fernand Hétu, commerçant, Yvette Fortin, secrétaire, célibataire, et Réal-Hétu, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'accessoires pour fins domestiques ou commerciales, sous le nom de \"Family Hostess Sales Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1460, rue Jean Talon, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10997558) F.X.La Salle & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le 'Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Paul Lcmieux, avocat, Mary Mathoul.secrétaire, épouse séparée de biens de Gaston Mathoul, et Lucille Roy, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de chaussures et d'articles en cuir, sous le nom de \"F.X.La Salle & Fils Inc.\".avec un capital total de $75,000, divisé en 2,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune, 680 actions privilégiées classe \"A\" d'une valeur au pair de $100 chacune et en 500 actions privilégiées classe \"B\" d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 580, rue Sainte-Catherine, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(A.G.11142-58) Évaporateur Portneuf Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twent» seventh day of March, 1958, incorporating: Real Cossette, industrialist, Mrs.Gisèle Quessy, Cossette, housewife, wife separate as.to property of the said Real Cossette and duly authorized by him and Lauriette Veillette, secretary, all of Portneuf-Station, for the following purposes: To carry on a business dealing in dairy products, eggs, flour and mashes, under the name of \"Évaporateur Portneuf Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Portneuf Station, judicial district of Quebec, Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11073-58) Family Hostess Sales Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1958, incorporating: Fernand Hétu, tradesman, Yvette Fortm, secretary, spinster, and Réal Hétu, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in accessories for domestic or commercial purposes, under the name cf \"Family Hostess Sales Limited\", with a total capital stock cf $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1460 Jean Talon Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE* 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10997-58) F.X.La Salle & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1958.incorporating: Paul Lemicux, advocate, Mary Mathoul, secretary, wife separate as to property of Gaston Mathoul, and Lucille Roy, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business of and dealing in shoes and leather articles, under the name of \"F.X.La Salle & Fils Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $1 each, 680 preferred class \"A\" shares of a par value of $100 each and into 600 preferred class \"B\" shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 580 Ste-Catherine St., East, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General. 1704 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC* Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 (P.G.10991-58) Gaétan Gagné Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Léonard Gagné, contremaître, de Jonquière, Gaétan Gagné, comptable, et Lilianne Bouliane, ménagère, épouse commune en biens dudit Gaétan Gagné, d'Alma, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'appareils et d'accessoires électriques; faire affaires comme bijoutiers et quincailliers, sous le nom de \"Gaétan Gagné Incorporée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 454, rue St-Hubert, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47097-o P.FRENETTE.(P.G.11023-58) Henry A.Cumin Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1958, constituant en corporation: Henry-A.Cant in, marchand et agent manufacturier, Mme Bérangère Nadeau Cantin, ménagère, épouse séparée de biens dudit Hcnry-A.Cantin, et Vincent Masson, avocat, tous de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de machines, moteurs, outils, instruments et quincaillerie de toutes sortes, sous le nom de \"Henry A.Cantin Incorporé\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2260 \u2014 1ère avenue, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.14178-57) Hers born Investment Inc.Avis eat donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1958, constituant en corporation: Norman Genser, de la ville de Hampstead, Sydney Phillips, de la ville de Côte St-Luc, tous deux avocats, Tessy Frankel, Rose Marie Bourgoin, secrétaires, célibataires et Diane Marchand, secrétaire, veuve hon-remariée, toutes trois de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de Elacements, sous le nom de \"Hershorn Investment ac\", avec un capital total de $220,000 divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.10991-58) Gaétan Gagné Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March 1958, incorporating: Léonard Gagné, foreman, of Jonquière, Gaétan Gagné, accountant, and Lilianne Bouliane, housewife, wife common as to property of the said Gaétan Gagné, of Alma, for the following purposes: To deal in electrical apparatus and appliances; carry on business as jewellers and hardwaremen, under the name of \"Gaétan Gagné Incorporée\", with a total capital of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 454 St.Hubert Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.C.11023-58) Henry A.Cantin Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April.1958, incorporating: Henry-A.Cantin, merchant and manufacturing agent, Mrs.Bérangère Nadeau Cantin, housewife, wife separate as to property of the said Henry-A.Cantin, and Vincent Masson, advocate, all of Quebec, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in machines, motors, tools, instruments j&na hardware of all kinds, under the name of \"Henry A.Cantin Incorporé\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 2260 \u2014 1st Avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14178-57) Hershorn Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1958, incorporating: Norman Genser, of the town of Hampstead, Sydney Phillips, of the town of Côte St.Luc, both attorneys, Tessy Frankel, Rose Marie Bourgoing, secretaries, unmarried, and Diane Marchand, secretary, unmarried, widow, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Hershorn Investment Inc.\", with a total capital stock of $220,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and into 20,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1958, Vol*90, No.19 1705 (P.g.11000-58) Hutchison Street Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1958, constituant en corpora-' tion: Mortimer Saul Smith, avocat, Shirley Simon et Claude Morin, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Hutchison Street Corporation\", avec un capital total de $100,000 divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 9,000 actions privilégiées de $10 chacune.^ Le siege social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.47697 P.FRENETTE.(P.G.10830-58) Integral Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1958, constituant en corporation: Monica Berzeanu Mateesco, professeur, mariée, séparée de biens en vertu des lois de la Roumanie à Nicolas Mateesco, de Montréal, Florence Goulet Seneca], secrétaire publique, mariée, séparée de biens en vertu des lois de la province de Québec, à George Senecal, et Marthe Laçasse Clo-ghesy, secrétaire, mariée, séparée de biens, en vertu des lois de la province de Québec à John Cloghesy, tous deux d'Outremont, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Integral Development Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 _ P.FRENETTE.(P.G.10789-58) Intercom of Montreal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corporation : Louis-Philippe Gagnon, avocat et conseil en loi de la Reine, d'Outremont, Paul L'Heureux, avocat, et Pauline Sauvé, secrétaire, de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme manufacturiers, entremetteurs, importateurs et exportateurs de système électriques en général et en partuclier de systèmes de sonorisation, intercommunication et signalisation, sous le nom de \"Intercom of Montreal Inc.\", avec un capital total de $500, divisé en 50 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(A.G.11000-58) Hutchison Street Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: Mortimer Saul Smith, advocate, Shirley Simon and Claude Morin, secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Hutchison Street Corporation\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 9,000 preferred shares of $10 each.The head office^ of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10830-58) Integral Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April, 1958, incorporating: Monica Berzeanu Mateesco, professor, married, separate maintenance, under the laws of Roumania, to Nicolas Mateesco, of Montreal, Florence Goulet Senecal, Public Secretary, married, separate maintenance, under the laws of the Province of Quebec, to George Senecal, and Marthe Laçasse Cloghesy, secretary, married, separate maintenance, under the laws of the Province of Quebec, to John Cloghesy, both of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Integral Development Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 50 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of April, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10789-58) Intercom of Montreal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tweritv-eighth day of March 1958, incorporating: Louis-Philippe Gagnon, advocate and Queen's Counsel, of Outremont, Paul L'Heureux, advocate, and Pauline Sauvé, secretary, of Montreal, for the following purposes: To act as manufacturers, intermediaries, importers and exporters of electric systems generally, and more particularly those of scoring of films, intercommunication and traffic lights, under the name of \"Intercom of Montreal Inc.\", with a total capital of $500, dividing into 50 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal, Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eightlf day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General. 1706 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90tN919 (P.G.1102248) Italian Motor Car Distributors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1958, constituant en cor- Knation: Milton L.Klein, avocat, Arthur D.uby, comptable, Iown Lanteigne et Claire Lubin, sténographes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et négocier des automobiles; exercer le commerce comme garagistes, sous le nom de \"Italian Motor Car Distributors Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 8,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.11114-58) j.Bernard Hamel, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: J.-Bernard Hamel, courtier d'assurance agréé, Mme Fernande Gagnon Hamel, ménagère, veuve de feu Joseph Hamel, et Colette Gagnon, sténographe, tous de Pont-Rouge, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents d'assurance et comme courtiers en valeurs mobilières, sous le nom de \"J.Bernard Hamel, Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pont-Rouge, comté de Portneuf, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.11013-58) j.Louis Voghcl Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corporation: Léonard Voghel, Leopold Pépin, et J.-Louis Voghel, tous commerçants, de Belœil, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en excavation et comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"J.Louis Voghel Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1288, boulevard Richelieu, Belœil, district.judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(A.G.11022-58) \u2022 Italian Motor Car Distributors Ltd.^Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1958, incorporating: Milton L.Klein, advocate, Arthur D.Ruby, accountant, Iown Lanteigne and Claire Lubin, stenographers, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles; to carry on business as garage keepers, under the name of \"Italian Motor Car Distributors Ltd.\",-with a total capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 8,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11114-58) j.Bernard Hamel, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'.Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March 1958, incorporating: J.Bernard Hamel, chartred insurance broker, Mrs.Fernande Gagnon Hamel, housekeeper, widow of the later Joseph Hamel, and Colette Gagnon, stenographer, all of Pont-Rouge, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, stock brokers, under the name of \"J.Bernard Hamcl, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Pont Rouge, county of Portneuf, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March 1958.P.FRENETTE, .47697 Acting Deputy Attorney General (A.G.11013-58) j.Louis Voghel Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Leonard Voghel, Leopold Pépin, and J.-Louis Voghel, all tradesmen, of Belœil, for the following purposes: - To carry on business as contractors in excavations and as general building contractors, under the name of \"J.Louis Voghel Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and into 4,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at 1288 Richelieu Boulevard, Belœil, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1707 (P.G.10013-58) ' Labrador Cut Rate Food Market Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit janvier 1058, constituant en corporation: Rosaire Beau lé, avocat, Claire Pigeon, secrétaire, célibataire majeure, tous deux de Montréal, et J.-Bernard Cariase, avocat, de Ville d'Anjou, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de produits alimentaires, sous le nom de \"Labrador Cut Rate Food Market Inc.\", avec un capital total de $10,-000, divisé en 25 actions communes de $100 chacune et en 75 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47607-o P.FRENETTE.(P.G/10412-58) La Cie d'Immeubles Dauville Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant «n corporation: Charles Coderre, avocat et conseil en loi de la Reine, d'Outremont, Annette Richard, de Bois-des-Filion, et France de la Casinière, de Verdun, toutes deux secrétaires, célibataires majeures, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"La Cie d'Immeubles Dauville Ltée\", avec un capital total de 155,000, divisé en 550 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à l'Ile-Perrot, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.10017-58) ~ Lamondo Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1058, constituant en corporation: William Ghenender, fabricant, Rose Ghe-nender, ménagère, épouse séparée de biens dudit William Ghenender, at dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, d'Outremont, Lillian Lazare, secrétaire, fille majeure, de Montréal et Jack Greenstein, avocat, de la ville Cote St-Luc, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles vestimentaires, textiles, bottes, chaussures, marchandises tricotées, camions, automobiles et autres véhicules moteurs, transiger les affaires d'une compagnies d'immeubles, construction, et amélioration, sous le nom de \"Lamondo Trading Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.10013-58) Labrador Cut Rate Food Market Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1958, incorporating: Rosaire Beaulé, advocate, Claire Pigeon, secretary, spinster of full age of majority, both of Montreal, and J.-Bernard Carisse, advocate, of the town of Anjou, for the following purposes: To carry on the business of and deal in foodstuffs, under the name of '-'Labrador Cut Rate Food Market Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 25 common snares of $100 each and 75 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10412-58) La Cie d'Immeubles Dauville Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March 1958, incorporating: Charles Coderre, advocate and Queen's Counsel, of Outremont, Annette Richard, of Bois-des-Filion, and France de la Casinière, of Verdun, both secretaries, spinsters of full age of majority, for the following purposes: Deal in real estate; carry on business as general building contractors, under the name of \"La Cie d'Immeubles Dauville Ltée\", with a total capital stock of $55,000, divided into 550 shares of $100 each.The head office of the company will be at He Perrot, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seevnth day of March, 1958.P.FRENETTE, 40697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10917-58) Lamondo Trading Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1958, incorporating: William Ghenender, manufacturer, Rose Ghenender, housewife, wife separate as to property of the said William Ghenender, and duly authorized by him for the purpose of these presents, of Outremont, Lillian Lazare, secretary, fille majeure, of Montreal, and Jack Greenstein, advocate, of the town of Côte St.Luc,, for the following purposes: To deal in wearing apparel, textiles, boots, shoes, knitted goods, trucks, automobiles and other motor vehicles; to carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Lamondo Trading Corporation\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 eacah.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. 1708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 (P.G.10361-68) L'Association des Médecins Bactériologistes de la Province de Québec Association of Medical Bacteriologists of the Province of Quebec Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1958, constituant en corporation .sans capital-actions: André Leduc, Hugh Starkey, de Montréal, Paul Dionne, de Cartier-ville, et léo Gauvreau, de Québec, tous médecins bactériologistes, pour les objets suivants: Contribuer au progrès de la Bactériologie médicale, sous le ncm de \"L'Association des Médecins Bactériologistes de la Province de Québec \u2014 Association of Medical Bacteriologists of the Provirce of Quebec\".Le montant auquel dont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $1C0.Le siège social de la corporation sera 15GO, rue Shcrbrocke, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47097-o P.FRENETTE.(P.G.10935-58) Laurentide Graphite Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mars 1958, constituant en corporation: Henri Crépeau, Jean Miquelon, avocats et conseils de la Reine, et Françoise Proulx, agent d'assurance, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Laurentide Graphite Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de $500,000, divisé en 500,000 actions «le $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera 161, 4ième avenue, Ville Saint-Pierre, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.10934-58) Laurentide Minerai Products Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1958, constituant en corporation: Henri Créneau', Jean Miquelon, avocats et conseils de la Reine, et Françoise Proulx, agent d'assurance, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de'\"Laurentide Minerai Products (A.G.10361-58) L'Association des Médecins Bactériologistes de la Province de Québec Association of Medical Bacteriologists of the Province of Quebec Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April 1958, to incorporation as a corporation without share capital: André Leduc, Hugh Starkey, of Montreal, Paul Dionne, of Cartier-ville, and Léo Gauvreau, of Quebec, all medical bacteriologists, for the following purposes: Contribute to the progress of medical bacteriology, under the name of \"L'Association des Médecins Bactériologistes de la Province de Québec \u2014 Association of Medical Bacteriologists of the Province of Quebec.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100.The head office of the corporation will be at 1560 Sherbrooke Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10935-58) Laurentide Graphite Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the seventeenth day of March 1958, incorporating: Henri Crépeau, Jean Miquelon, advocates and Queen's Counsel, and Françoise Proulx, insurance agent, unmarried, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Laurentide Graphite Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital of $500,000, divided into 500,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 161 \u20144th.Avenue, town of St.Pierre, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of March 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10934-58) Laurentide Mineral Products Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: Henri Crépeau, Jean Miquelon, advocates and Queen's Counsel, and Françoise Proulx, insurance agent, unmarried, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Laurentide Mineral Products Corporation\" (No Personal QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Fol.90, No.19 1709 Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de $200,000, divisé en 200,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera 161, 4ième avenue, Ville Saint-Pierre, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10565-58) Léo Paul Charbonncau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: Léo-Paul Charbonncau, entrepreneur en construction, Claire Charbonneau, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Léo-Paul Charbonneau et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Roland Robillard, avocat, tous de Rosemère, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Léo Paul Charbonneau Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 215, Grande Côte, Rosemère, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10999-58) Leran Copper Mining Company Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en dtae du dix-neuf mars 1958, constituant en corporation: André Gagnon, Claude Gagnon, Gilles de Billy, tous trois avocats, de Sillery, Jacques de Billy, avocat, et Lu-cile Rioux, secretaire, fille majeure, tous deux de Québec, pour les objets suivants: Faire des recherches et explorations pour découvrir des mines et minerais, et les négocier, sous le nom de \"Leran Copper Mining Company Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10998-58) Les Immeubles F.X.LaSalle & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Liability), with a total capital of $200,000, divided into 200,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or- agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 161, 4th.Avenue, town of Saint Pierre, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10565-58) Léo Paul Charbonneau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: Léo-Paul Charbonneau, building contractor, Claire Charbonncau, secretary, wife separate as to property of the said Léo-Paul Charbonneau and duly authorized by him for the purposes therein, and Roland Robillard, advocate, all of Rosemère, for the following purposes: To deal in real estate; carry on business as general building contractors, under the name of \"Léo Paul Charbonneau Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 215 Grande Côte, Rosemère, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10999-58) Leran Copper Mining Company Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: André Gagnon, Claude Gagnon, Gilles de Billy, all three advocates, of Sillery, Jacques de Billy, advocate, and Lucile Rioux, secretary, spinster, both of Quebec, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Leran Copper Mining Company Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10998-58) Les Immeubles F.X.LaSalle & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have 1710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N* 19 été accordé T>ar le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1058, constituant en corporation: Paul Lemieux, avocat, Mary Mathoul, secrétaire, épouse séparée de biens de Gaston Mathoul, et Lucille Roy, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles F.X.LaSalle & Fils Inc.\", avec un capital total de 1200,000, divisé en 4,000 actions communes d'une valeur au pair de 11 chacune 2,000 actions privilégiées classe \"A\" d'une valeur au pair de $100 chacune et en 500 actions privilégiées classe \"B\" d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 580, rue Ste-Catherine est, Montréal, district judiciaire de-Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47607-o P.FRENETTE.(P.G.10666-68) ' Loisirs Notre-Dame des Monts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Adrien Bazinet, directeur de funérailles, Charles-A.Jobin, gérant, Ludger Guénette, employé au C.P.R., René Desjardins, opérateur, et Paul Martineau, directeur, tous de Montréal, pour les objets suivants: Organisation des loisirs des jeunes filles de la paroisse St-Jean Berchmans de Montréal, sous le nom de \"Loisirs Notre-Dame des Monts Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $15,000.* Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10614-68) Lord & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1958, constituant en corporation: Philippe Lamarre, Marc Lamarre, avocats, de Longueuil, et Jocelyne Gill, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme maîtres de forge, fondeurs et ouvrier en métaux, sous le nom de \"Lord & Fils Inc.\", avec un capital total de $49,000, divisé en 5,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 870, rue Préfontaine, Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1958.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing daté the twentieth day of March, 1968, incorporating: Paul Lemieux, advocate, Mary Mathoul, secretary, wife separate as to property of Gaston Mathoul, and Lucille Roy, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business of and dealing in immoveables, under the name of \"Les Immeubles F.X.LaSalle & Fils Inc.\".with a total capital stock of $299,900, dividde into 4,000 common shares of a par value of $1 each, 2,000 preferred class \"A\" snares of a par value of $100 each and into 600 preferred class \"B\" shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 580 Ste-Catherine St.East, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1058.\u2014 P.FRENETTE.47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10666-58) Loisirs Notre-Dame des Monts Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, to iu corpora te as a corporation without share capital: Adrien Bazinet, undertaker, Charles-A.Jobin, manager, Ludger Guénette, C.P.R.employee, René Desjardins, operator, and Paul Martineau, manager, all of Montreal, for the following purposes: To organize recreational activities for the young girls of the parish of St.Jean Berchmans of Montreal, under the name of \"Loisirs Notre-Dame des Monts Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $15,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General (A.G.10614-58) Lord & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March 1958, incorporating: Philippe Lamarre, Marc Lamarre, advocates, of Longueuil, and Jocelyne Gill, secretary, of full age of majority making use of her rights, of Montreal for the following purposes: To carry on business as iron-masters, metal founders and workers, under the name of \"Lord & Fils Inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 870 Préfontaine Street, Jacques Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebte, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1711 (P.G.10476-68) L'Union des Jardiniers, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1958, constituant en corporation: J.-B.-Eugène Roy, rentier, Mme Êmilienne Gagnon Roy, ménagère, épouse séparée de biens dudit J.-B.-Eugène Roy, et Rosaire Roy, commis, tous de Levis, pour les objets suivants: Exercer le commerce de graines de semence, engrais, primes, bibelots et cartes de souhaits, sous le nom de '^L'Union des Jardiniers, Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o \u2022 P.FRENETTE.(P.G.11112-58) M.A.Blouin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ' province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: Marc-André Blouin, courtier en assurances, Pierre Le sage, notaire, tous deux de Sillery, et Claude Royer, notaire, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents d'assurances, sous le nom de \"M.A.Blouin.wlnc\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 378, rue du Roi, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.11069-58) Magasin Jat (Dolbeau) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de là province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1958, constituant en corporation: Joseph-Arthur Tremblay, marchand, de Jonquière, Jean-Marc Leclerc, marchand, et Jean-Louis Thibault, comptable, de Roberval, pour Jes.objets suivants: Faire affaires comme épiciers, charcutiers et bouchers, sous le nom de \"Magasin Jat (Dolbeau) Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dolbeau, district judiciaire de Roberval._ Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.11032-58) Magasin Lemieux Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la (A.G.10475-58) - ^ L'Union des Jardiniers, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April, 1958, incorporating: J.-B.Eugène Roy, annuitant, Mrs.Êmilienne Gagnon Roy, housewife, separate as to property of the said J.-B.Eugène Roy, and Rosaire Roy, clerk, all of Levis, for the following purposes: To carry on a business dealing with seeds, fertilizer, premiums, bibelots and greeting cards, under the name of \"L'Union des Jardiniers, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April, 1958., P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11112-58) M.A.Blouin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: Marc-André Blouin, insurance broker, Pierre Lesage, notary, both of Sillery, and Claude Royer, notary, of Quebec, for the following purposes: To carry on as insurance brokers and agents, under the name of \"M.A.Blouin Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 378 du Roi Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11069-58) Magasin Jat (Dolbeau) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1958, incorporating: Joseph-Arthur Tremblay, merchant, of Jonquière, Jean-Marc Leclerc, merchant, and Jean-Louis Thibault, accountant of Roberval for the following purposes: To carry on business as grocers, delicatessen and butchers, under the name of \"Magasin Jat (Dolbeau) Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Dolbeau, judicial district of Roberval.Dated at the office of the.Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P,.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11032-58) Magasin Lemieux Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 1712 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corporation: Yolande Roy, secrétaire, Eugène Lamou-reux, comptable, et Camille Messara avocat, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de tissus et de vêtements, sous le nom de \"Magasin Lemieux Inc.\", avec un capital total d e $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $ 100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.10966-58) Maisonneuve Textiles Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1958, constituant en corporation : Irving L.Adessky, Moses Moscovite h et Melvin Salmon, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires, accessoires de ménage et textiles, sous le nom de \"Maisonneuve Textiles Ltd.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 350 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mare 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10794-58) Marcel Drouin j^j* Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corporation: Marcel Drouin, marchand, Jules Drouin, gérant, et Claude Goyette, comptable, tous de Ville St-Pierre, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'accessoires de plomberie et de chauffage, outillage, matériel et matériaux de construction, sous le Ltée nom de \"Marcel Drouin j^j \", avec un capital total de $100,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 950 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 233, rue St-Jacques, Ville Saint-Pierre, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.11017-58) Marché Union Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des\" lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Yolande Roy, secretary, Eugene Lamoureux, accountant, and Camille Messara, advocate, all of Sherbrooke, for the following purposes: .To carry on an industry and business dealing in fabrics and clothing under the name of \"Magasin Lemieux Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated, at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10966-58) Maisonneuve Textiles Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch and Melvin Salmon, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, household accessories and textiles, under the name of \"Maisonneuve Textiles Ltd.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 350 common shares of a par value of $100 each and into 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10794-58) Marcel Drouin Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March 1958, incorporating: Marcel Drouin, merchant, Jules Drouin, manager, and Claude Goyette, accountant, all of the town of St.Pierre, for the following purposes: To carry on the business of and deal in plumbing and heating accessories, tooling, building materials, and supplies, under the name of Ltée \"Marcel Drouin \", with a total capital of $100,000, divided into 50 common shares of a par value of $100 each and 950 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 233 St.James Street, town of St.Pierre, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11017-58) Marché Union Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1713 du dix-neuf mars 1058, constituant en corporation: Hyman Wienstein, marchand, Lillian Adel-son, ménagère, épouse séparée de biens dudit Hyman Wienstein, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, de Montréal, Hyman Weinstein, marchand, et Anne Gordon, ménagère épousé séparée de biens dudit Hyman Weinstein, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer un commerce de bouchers et épiciers, sous le nom de \"Marché Union Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47607 P.FRENETTE.(P.G.10071-58) Mazel Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1058, constituant en corporation: Mortimer S.Smith, avocat, Shirlee Simon, Claude Morin, secrétaires, et Ellen Haggen-mueller.commis, toutes trois filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Mazel Corporation\", avec un capital total de $1,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47607 P.FRENETTE.day of March, 1058, incorporating: Hyman Wienstein, merchant, Lillian.Adebon, housewife, wife separate as to property of the said Hyman Wienstein, and duly authorized by him for the purpose of these presents, of Montreal, Hyman.Weinstein, merchant, and Anne Gordon, housewife, wife separate as .to property.of the said, Hyman Weinstein, and duly authorized by him' for the purpose of these presents, of the town o/ Cûte St.Luc, for the following purposes: .< To carry on business as butchers and as grocers, under the name of \"Marché Union Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided) into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 400 preferred shares of a par value of $100 each.f.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General' this nineteenth day of March, 1058.P.FRENETTE, 47607-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10071-58) Mazel Corporation - Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1058, incorporating: Mortimer S.Smith, advocate, Shirlee Simon, Claude Morin, secretaries, and Ellen Haggenmueller, clerk, all three filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: .To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Mazel Corporation\", with a total capital stock* of $1,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be .at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11026-58) Montserrat Poultry Farms Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf mars 1958, constituant en corporation: David Mortimer Notkin, avocat, de Westmount, Mary Connor, Pâquerette Théorêt, secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, et Maurice Joseph Boxer, avocat, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce, posséder et exploiter des couveuses artificielles et fermes d'élevage de volailles et en vendre les produits, sous le nom de \"Montserrat Poultry Farms Inc.\", avec un ca-capital total de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Frelighs-burg, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mars 1958.(A.G.11026-58) Montserrat Poultry Farms Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of March, 1958, incorporating: David Mortimer Notkin, advocate, of Westmount, Mary Conner, Pâquerette Théorét, secretaries, filles majeures et usant de leurs droits, and Maurice Joseph Boxer, advocate, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of owning and operating hatcheries and poultry farms and of selling the products thereof, under the name of \"Mont-' serrât Poultry Farms Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Frelighsburg, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of March, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. 1714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 (P,G.1080948) Nivel Realties, Inc.' Avis, est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corpo-.ration: Nathan Le vine, constructeur, Avrom Podbere and Leonard Wisse, -notaires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et développement, sous le nom de \"Nivel Realties, Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de.la compagnie sera à 4855 avenue Isabella, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10937-58) Old Rose Printing Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze mars 1958, constituant en corporation: Albert Marcus, Isidore Reuben Prazoff, Abraham - Fciner, avocats, et Myrna Katz, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs, libraires, et éditeurs, sous le nom de \"Old Rose Printing Ce.Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47097 ' ¦ P.FRENETTE.(P.G.11102-58) Paradis Construction Ltd.Paradis Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: Rosaire-Maurice Paradis, constructeur, de St-Elzéar, Seymour Machlovitch et David Litner, avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Trasiger les affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Paradis Construction Ltd.\u2014 Paradis Construction Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires, d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Elzéar, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.(A.G.10809-58) Nivel Realties, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Nathan Le vine, builder, Avrom Podberer and Leonard Wisse, notaries, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Nivel Realties, Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at 4855 Isabella Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10937-58) Old Rose Printing Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of March, 1958, incorporating: Albert Marcus, Isidore Reuben Prazoff, Abraham Feiner, advocates, and Myrna Katz.secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as printers, booksellers and publishers, under the name of \"Old Rose Printing Co.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the* Attorney General, this fifteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11102-58) Paradis Construction Ltd.Paradis Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: Rosaire-Maurice Paradis, builder, of St.Elzéar, Seymour Machlovitch and David Litner, advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Paradis Construction Ltd.\u2014 Paradis Construction Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at St.Elzéar, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, % 19., 1715 (P,G.11006-58) Pasoff Holdings Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation : Julius Briskin, Arthur Yanofsky, avocats, et Max Shrier, gérant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles; acquérir, construire, exploiter, gérer, vendre ou autrement disposer de bâtisses et constructions de toutes sortes et aussi faire le commerce de matériaux de construction et accessoires, sous le nom de \"Pasoff Holdings Incorporated\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10123-58) P.E.Légaré Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: Paul-Emile Légaré, marchand, Germaine Guay Légaré, ménagère, épouse contractuelle-ment séparée de biens dudit Paul-Émile Légaré, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Claude Bordeleau, comptable, tous de Dolbeau, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de vêtements faire affaires comme teinturiers et nettoyeurs, sous le rem de \"P.E.Légaré Inc.\".avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'ure valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dolbeau, district ji diciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.10973-58) Penrose Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Samuel Shriar, avocat, Earl Kruger, notaire, et Helen Shaftesley, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Penrose Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et 1,600 actions privilégiées de $100 chacune.¦ Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.11006-58) .; ., Pasoff Holdings Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of thé Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: Julius Briskin1, Arthur Yanofsky, advocates, and Max Shrier, manager, all of Montreal, for the following purposes: To deal in and with real property; to acquire, construct, operate, manage, sett or otherwise dispose of buildings and structures of all kinds and to deal in and with building materials and supplies, under the name of \"Pasoff Holdings Incorporated\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of V par value of $100 each and into 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10123-58) P.E.Légaré Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: Paul-Emile Légaré, merchant, Germaine Guay Légaré, housewife, wife contractually separate as to property of the said Paul-Émile Légaré, and duly authorized by him for these present purposes, and Claude Bordeleau, accountant, all of Dolbeau, for the following purposes: v , To carry on a business dealing in clothing; to operate an industry as dyers and cleaners, under the name of \"P.E.Légaré Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.,.The head office of the company will be at Dolbeau, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of Marchi 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10973-58) Penrose Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, gearing date the twentieth day of March, 1958, incorporating: Samuel Shriar, advocate, Earl Kruger, and Helen Shaftesley, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Penrose Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 400 common shares of $100 each and into 1,600 preferred shares of $100 each.The head office of the company will bejat Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General. 1716 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N* 19 (P.g.1(00548) Pcrma Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première rie de la Loi des compagnies de Québec, il a accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: Julius Bris kin, Arthur Yanofsky, avocats, et Max Shrier, gérant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Perma Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 100 actions, catégorie \"A\" d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G: 11005-58) Perma Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: Julius Briskin, Arthur Yanofsky, advocates, and Max Shrier, manager, all of Montreal, for the follow-img purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Perma Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 900-common shares of a par value of $10 each, 100 Class \"A\" shares of a par value of $10 each and into 3,000 Class \"B\" shares of a par value of $10 each.The head- office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10965-58) Provincial Hardwoods Inc.Avis est donné qu'en vertu de_.la première partie de> la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars.1958, constituant en corporation: Jacques Morin, étudiant en médecine, Lucilc Morin, coiffeuse, tous deux de Québec, et Fidèle Morin, mesureur, de Jacques Cartier, tous Célibataires, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le cemmerce du bois èt des pre du i ts du bois, sous le nom de \"Provincial Hard weeds Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions communes de $5 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $5 chacune.1 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.\u2022 Daté du bureau du Procureur général, le dix-oeuf mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant; 47697-© P.FRENETTE.(P.G.1111548) Restaurant.Horizon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation : Richard Roy, commis, Marc Langlois, cyisinier, André Morissette, maître d'hôtel, tous trois de Québec, Paul Beauregard, notaire, de Beaupré, et Florian Gagnon, hôtelier, de Sillery, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de \"Restaurant Horizon Inc.\", avec bn capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera au Centre d'achats de Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept inars 1958.(A.G.10965-58) Provincial Hardwoods Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing \"date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: Jacques Morin, medical student, Lucile Morin, hairdresser, both of Quebec, and Fidèle Morin, culler, of Jacques Cartier, all unmarried, for the following purposes: To carry on the business of and deal in lumber, and the products thereof, under the name of \"Provincial Hardwoods, Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common chares of $5 each and 1,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11115-58) ' Restaurant Horizon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have .been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: Richard Roy; clerk, Marc Langlois, cook, André Morissette, head waiter, all three of Quebec, Paul Beauregard, notary, of Beaupré, and Florian Gagnon, hotel-keeper, of Sillery, for the following purposes: To carry on business as restaurant-keepers, under the name of \"Restaurant Horizon Inc.\", with a total capital stock of $1067000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at the Purchasing Center of Ste-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1717 (P.G.1093048) Rock Lagacé & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Theodore H.Shapiro, avocat et Jean McFarlane.teneuse de livres, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction, portefeuille et placements, sous le nom de \"Rock Lagacé & Co.Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses activités sera $500.Le siège social de la compagnie sera à Dorion, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.47697 P.FRENETTE.(P.G.11027-58) Roy Auto Parts Inc.\u2022Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi ces compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1958, constituant en corporation: Maurice Roy, vendeur, Alphonse Bessette, entrepreneur, et Jean-Maurice Charbonneau, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'accessoires et de pièces d'automobiles; faire affaires comme quincailliers, sous le nom de \"Roy Auto Parts Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697k» _ P.FRENETTE.(P.G.11016-58) Sheres Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1958, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack, avocats, et Ted Sheres, marchand, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de fournitures de maisons et accessoires, meubles, articles de fumeurs, cadeaux, porcelaine, poterie, jouets, menus objets, quincaillerie, dispositifs électriques, nouveautés, accessoires de comptoir, marchandises sèches, articles en cuir, bijouterie, ornements, textiles, articles d'étalages pour fleuristes, objets d'art, gravures et peintures, sous le nom de \"Sheres Company Ltd.', avec un capital total de $60,000, divisé en 60 actions ordinaires de $100 chacune et 540 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.10930-58) Rock Lagacé & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: Benjamin Robinson, advocate and Queen's Ceunseil, of Westmount, Theodore H.Shapiro, advocate, and Jean McFarlane, bookkeeper, spinster of the full age of majority, both of Montreal, for the following purposes: - ¦ To carry on the business of a real estate, construction, holding and investment company, under the name of \"Rock Lagacé & Co.Ltd.\", with a capital] stock divided into 100 shares without nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $500.The head office of the company will be at Dorion, judicial distirct of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11027-58) Roy Auto Parts Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth tlay of March, 1958, incorporating: Maurice Roy, salesman, Alphonse Bessette, contractor, and Jean-Maurice Charbonneau, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To operate and jndustry and business dealing in accessories and automobile parts; to carry on business as hardware dealers under the name of \"Roy Auto Parts Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Eustache, judicial district of Terrebonne, Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11016-58) Sheres Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1958, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack, advocates, and Ted Sheres, merchant, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in house furnishings and appliances, furniture, smokers' supplies, giftware, chinaware, pottery, toys, smallwares, hardware, electrical appliances, ' novelties, bar accessories, dry goods, leather goods, jewellery, ornaments, textiles, florists supplies, artware, pictures and paintings, under the name _ of \"Sheres Company Ltd.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 60 common shares of $100 each and into 540 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-0 Acting Deputy Attorney General. 1718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, 19 (P.G.10968-58) Sol Luncheonnettes Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1958, constituant en corporation: Monroe Abbey, de Westmount, Max Slapack, de la ville Côte St-Luc, et Arthur Shulman, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants r Exercer le commerce de restaurateurs, hôteliers, taverniers, et aubergistes, sous le nom de \"Sol Luncheonnettes Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.10968-68) Sol Luncheonnettes Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1968, incorporating: Monroe Abbey, of Westmount, Max Slapack, of the town of Côte St.Luc, and Arthur Shulman, of Montreal, all advocates, for the following purposes : To carry on the business of restaurant, hotel, tavern and inn keepers, under the name of \"Sol Luncheonnettes Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10784-58) Spécialités Lucerne Specialties Inc.Avis eft donné qu'en vertu de la première partie de la* Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieuterant-gouyemeur de la province de Québec des letttes patentes, en date du virgt-six mars 1958, constituant en corcora-tion: Lcuis-Fhilippe Gagnon.avocat et conseil en loi de la Reine, d'Outremont, Paul L'Heureux, avocat, et Pauline Sauvé, sec refaire, tous deux de Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'appareils de plomberie, chauffage, cuisson, ventilation^ climatisation de l'air, de réfrigération et autres appareils, outillages et prrduits métalliques, sous le nom de \"Spécialités Lucerne Specialties Ire\", avec un capital total de $1,CC0, divisé en 100 actions de $10 chacune.Le sit ce fecial de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1C58.L'Assistant-procureur gérerai Furpléart, 47697-o P.FRENETTE.(A.G.10784-58) Spécialités Lucerne Specialties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1958, incorporating: Louis-Philippe Gagnon.advocate and Queen's Counsel, of Outremont, Paul L'Heureux, advocate, and Pauline Sauvé, secretary, both of Montreal, for the following purpose* To carry on a business dealing apparatus for plumbing, heating, cocking, ventilation, air-conditioning, refrigeration, and.other apparatus, equipment and metallic-products, under the name of \"Spécialités Lucerne Specialties Inc.\", with a total capital stock of $1,CC0, divided into 1C0 shares of $10 each The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the efface of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10480-58) St Antoine Excavation Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1958, constituant en corporation: Jean-Paul Therrien, entrepreneur, Dame Laurence Desjardins Therrien, ménagère, épouse contra» t celle ment séparée de biens dudit Jean-Paul Therrien, de St-Antoine-des-Laurentides, et Hervé Lauzon, comptable, de St-Jérôme, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"St Antoine Excavation Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1031, boulevard St-Antoine, Saint-Antoine-des-Lau-rentides, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(A.G.10480-58) St Antoine Excavation Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March 1958, incorporating: Jean-Paul Therrien, contractor, Dame Laurence Des-jardins Therrien, houfewife, wife contractually separate as to property of the said Jean-Paul Therrien, of St.Antoine-des-Laurentides, and Hervé Lauzon, acdountant, of St.Jérôme, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name of \"St Antoine Excavation Ltée\", with a total capital of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 1031 St.Antoine Boulevard, Saint Antoine-des-Laurentides, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney Genera). QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, So.19 1719 (P.G.13763-67) St.Leonard Realties, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente mars 1968, constituant en corporation: George Irwin Harris, avocat, de la ville Côte St-Luc, John Jacob Gotlieb, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Montréal, et Zygmunt Celi-chowski, gérant de bureau, de ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"St.Leonard Realties, Inc.\", avec un capital total de $6,000, divisé en 200 actions ordinaires de $6 chacune et 40 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 400 ouest, rue St-Jacques, (chambre 402), Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente mars 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.11016-68) Terminal Packaging & Warehousing Company Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958.constituant en corporation: Clarence Francis McCaffrey, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Montréal, William Hushicn, de la ville de Hampstead, Donald Ernest Hushicn, de Westmount.Paul .1.Landers, de ville Ment-Royal, tous trois administrateurs, et Mildred Callaghan, secrétaire, d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer un /cmmere e général d'emballage et celui d'entreposage général, sous le nom de 'Terminal Packaging & Warehousing Company Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.11007-68) Villa Labelle Holdings Corp.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mars 1958, constituant en corporation: William Klein, courtier d'immeubles, Stanley Haltrecht, notaire, tous deux de Montréal, et Maurice Gold, comptable agréé, de St-Laurent, pour les objets suivants: Transiger -les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Villa Labelle Holdings Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(A.G.13753-57) St.Leonard Realties, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of March, 1968, incorporating: George Irwin Harris, advocate, of the town of Côte St.Luc, John Jacob Gotlieb, advocate and Queen's Counsel, of Montreal, and Zygmunt Celichowski, office manager, of the town of Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"St.Leonard Realties, Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 200 common shares of $5 each and into 40 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 400 St.James Street, West, (Room 402), Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.110J5-58) Terminal Packaging & Warehousing Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: Clarence Francis McCaffrey, barrister and Queen's Counsel, of Montreal, William James Hushion, of the town of Hampstead, Donald Ernest Hushion, of Westmount, Paul J.Landers, of the town of Mount Royal, all three executives, and Mildred Callaghan, secretary, ot- Outremont, for the following purposes: To carry en a general packaging business; to carry on the business of general warehousing, under the name of \"Terminal Packaging & Warehousing Company Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11007-68) VUla Labelle Holdings Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of March, 1958, incorporating: William Klein, real estate broker, Stanley Haltrecht, notary, both of Montreal, and Maurice Gold, chartered accountant, of St.Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Villa Labelle Holdings Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-0 Acting Deputy Attorney General. 1720 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 (P.G.' 11031-68) W & D Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1968, constituant en corporation: Yolande Roy, secrétaire, Eugène Lamou-reux, comptable, et Camille Messara, avocat, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de passagers et de marchandises par voie de terre, sous le nom de \"W & D Transport Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Windsor-Mills, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 47097-o P.FRENETTE.(P.G.10698-58) Welwort Construction Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mars 1958, constituant en corporation: Louis Orenstein, d'Outremont, Bernard Diamond, Jason Ruby, de Montréal, tous trois avocats, et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Perrot, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles; transiger les affaires d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Welwort Construction Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.t Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal., Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697 P.FRENETTE.(P.G.10438-58) William j.Segal & Sons Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1958, constituant en corporation: Louis Orenstein, d'Outremont, Jason Ruby, de Montréal, tous deux avocats,-et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Perrot, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires, sous le nom de \"William J.Segal & Sons Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mars 1958.(A.G.11031-68).W & D Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Yolande Roy, secretary, Eugene Lamoureux, accountant, and Camille Messara, advocate, all of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on a transportation business dealing in the transportation of passengers and merchandise on land, under the name of \"W & D Transport Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common snares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Windsor-Mills, judicial district of St-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10698-58) Welwort Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of March, 1958, incorporating: Louis Orenstein, of Outremont, Bernard Diamond, Jason Ruby, of Montreal, all three advocates, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of He Perrpt, for the following purposes: To deal in immoveable properties; to carry on the business of a construction company, under the name of \"Welwort Construction Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of March, 1968.P.FRENETTE, 47697-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10438-58) William j.Segal & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1958, incorporating: Louis Orenstein, of Outremont, Jean Ruby, of Montreal, both advocates, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of He Perrot, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"William J.Segal & Sons Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferreed shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697-0 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procuteur général suppléant, 47697 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Hay 10th, 1958, Vol.90, No.19 1721 (P.G.1097048) (A.G.10970-68) Winer & Chazonoff Contractors Corp.Winer & Chazonoff Contractors Corp.Ayis est donné qu'en vertu 'de la première Notice is hereby given that under Part.I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date province of Quebec, bearing date the first day du premier avril 1968, constituant en corpora- of April, 1968, > incorporating: Edward Irving tion: Edward Irving Auerback, avocat et solli- Auerback, barrister and solicitor, Madeline citeur, Madeline Ferguson et Miriam Bernard, Ferguson and Miriam Bernard, secretaries, spins-secretaires, filles majeures et en pleine possession ters of the full age of majority and in the full de leurs droits, tous de Montréal, pour les objets enjoyment of all their rights, all of Montreal, for suivants: the following purposes: Exercer un commerce d'entrepreneurs généraux To carry on the business of general contractors et plombiers, sous le nom de \"Winer & Chazonoff and plumbers, under the name of \"Winer & Contractors Corp.\", avec un capital total de Chazonoff Contractors Corp.\", with a total $300,000, divisé en 3,000 actions ordinaires capital stock of $300,000, divided into 3,000 d'une valeur au pair, de $10 chacune et 6,400 common shares of a par value of $10 each and actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 into 5,400- preferred shares of a par value of chacune.$50 each.Le siège social de la compagnie sera à 6805 The head office of the company will be at boulevard Décarie, Montréal, district judiciaire 6805- Decarie Blvd., Montreal, judicial district de Montréal- .of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le pre- Dated at the office of the Attorney General, mier avril 1958.this first day of April, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 47697 P.FRENETTE.47697-o Acting Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent (P.G.13854-57) Camp Hiawatha Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en -date du vingt-quatre mars 1958, à la compagnie \"Wenerville Hotel Co.Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 15 janvier 1946, changeant son nom en celui de \"Camp Hiawatha Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.1103048) Les Fermes du Cap St-Jacques Ltée Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-cinq mars 1958, à la compagnie \"Les Fermes du Cap St-Jacques Ltée\", changeant ses pouvoirs et modifiant en conséquence les dispositions de ses lettres patentes de constitution en corporation.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.1074848).L.J.Forget & Cie Ltée L.J.Forget & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux mars 1958, à la (A.G.13854-57) Camp Hiawatha Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated twenty-fourth day of March, 1958, to the company \"Wenerville Hotel Co.Inc.\" incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of January 15, 1946, changing its name into that of \"Camp Hiawatha Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11030-58) .¦ Les Fermes du Cap St-Jacques Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-fifth day of March 1958, to the company \"Les Fermes du Cap St-Jacques Ltée\", changing its powers and modifying the provisions of its corporate letters patent.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10748-58) L.J.Forget & Cie Ltée L.J.Forget & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Qucl>ec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of jQuebec, dated the twenty-second day of March 1958, to the 1722 GAZETTE OFFICIELLE pE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 compagnie \"L.J.Forget Ltée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 27 septembre 1954, 1° augmentant son capital de $100,000 à $350,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,250 actions ordinaires de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune; 2° changeant son nom en celui de \"L.J.Forget & Cie Ltée \u2014 L.J.Forget & Co.Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mars 1958.- L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.11008-58) Vanguard Explorerions Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un mars 1958, à la compagnie \"Bando Oil & Minerals Corporation\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes du 4 février 1958, changeant son nom en celui de \"Vanguard Explorations Limited\" (No Personal Liability).Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mars 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.Action en séparation de biens Canada, province de Québec, district de Québec Cour Supérieure, N° 90-729; Dame Marie Lina Lecours: domiciliée à 18 rue St-Vallier Ouest, Québec, épouse commune en biens de Joseph Emmanuel Eugène Turgeon, domicilié à Québec, actuellement résidant à 52 rue St-Jo-seph Est.Québec, demanderesse, vs Joseph Emmanuel Eugène Turgeon, domicilié à 52 rue St-Joseph, Est, Québec, défendeur.AVIS Dame Marie Lina Lecours, domiciliée à 18, rue St-Vallier Ouest, Québec* épouse commune en biens de Joseph Emmanuel Eugène Turgeon, a formé contre son mari une demande de séparation de biens.Québec, le 18 avril 1958.Le Procureur de la demanderesse, 47707-o S) RAYNOLD BÉLANGER.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL-CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 430 Québec, le 1er mai 1958.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant certains actes administratifs du département des Affaires municipales.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui suit: company \"L.J.Forget Ltée\", constituted as'a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated September 27, 1954, 1.increasing its capital from the sum of $100,000 to $350,000: the additional share capital being divided into 2,250 common shares of $100 each and 250 preferred shares of $100 each; 2.changing its name to that of \"L.J.Forget & Cie Ltée \u2014 L.J.Forget & Co.Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney Genera).(A.G.11008-58) Vanguard Explorarions Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act, and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated March twenty-first, 1958, to the company \"Bando Oils & Minerals Corporation\" (No Personal Liability), incorporated under the said Quebec Mining Act by letters patent of February 4,1958, changing its name into that of \"Vanguard Explorations Limited\" (No Personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of March, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.Action for separation as to property Canada.Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court, No.90-729.Dame Marie Lina Lecours, domiciled at 18 St-Vallier Street, West, Quebec, wife common as to property of Joseph Emmanuel Eugène Turgeon, domiciled at Quebec, presently residing at 52 St-Joseph Street, East, Quebec, plaintiff, vs Joseph Emmanuel Eugène Turgeon, domiciled at 52 St-Joseph Street, East, Quebec, defendant.NOTICE Dame Marie Ljna Lecours, domiciled at 18 St-Vallier Street, West, Quebec, wife common as to property of Joseph Emmanuel Eugène Turgeon, has instituted against her husband an action for separation as to property.Quebec, April 18, 1958.S) RAYNOLD BÉLANGER, 47707 Attorney for the plaintiff.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 436 Quebec, May 1st, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting certain administrative agreements of the Department of Municipal Affairs.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Municipal Affairs, as follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1958, Vol.90, No.19 1723 Preuve photographique de certain» documenté Conformément et sous l'autorité de l'article 6 du Statut 5-6 Elizabeth II, chapitre 67, la Loi concernant la preuve photographique de certains documents est déclarée applicable à la ville d'Hampstead, à la suite d'une demande contenue à la résolution adoptée par le conseil de ladite ville le 15 avril 1958.(Signé): L.DÊSILETS, 47714-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 436 Québec, le 1er mai 1958.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant certains actes administratifs du département des Affaires municipales.Il est ordonne, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Preuve photographique de certaine documente ¦ Conformément et sous l'autorité de l'article 6 du Statut 5-6 Elizabeth H.chapitre 67, la Loi concernant la preuve photographique de certains documents est déclarée applicable à la cité de Hull, à la suite d'une demande contenue à la résolution adoptée par le conseil de ladite cité le 1er avril 1958.(Signé): L.DÊSILETS, 47714-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 387 Quebec, le 24 avril 1958.Présent: Le lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une convention collective de travail relative aux barbiers-coiffeurs de la région de Hull.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La Section des Patrons-Barbiers-Coiffeurs du Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du district de HuU; Et, d'autrb part: La Section des Employés-Barbiers-Coiffeurs du Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du district de Hull; pour les employeurs et les salariés de la profession visée, suivant les conditions décrites dans la Gazette Officielle de Québec, édition du 19 janvier 1957; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans la profession visée et dans la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête; Photographie Proof of Certain Documents In conformity and under the authority of section 6 of Statute 5-6 Elizabeth H, chapter 67, the Act respecting photographic proof of certain documents is declared applicable to the town of Hampstead, following a request contained in the resolution adopted by the Council of the said Town of April 15, 1958.(Signed): L.DÊSILETS, 47714 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIX CHAMBER Number 436 Quebec, May 1st, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting certain administrative agreements ¦ of the Department of Municipal Affairs.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Municipal Affairs, as follows: Photographic Proof of Certain Document», In conformity and under the authority of section 6 of Statute 5-6 Elizabeth II, chapter 67, the Act respecting photographic proof of certain documents is declared applicable to the city of Hull, following a request contained in the resolution adopted by the Council of the said city on April 1st, 1958.(Signed): L.DÊSILETS, 47714 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 387 Quebec, April 24, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a collective labour agreement relating to barbers and hairdressers in the region of Hull.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: \"La Section des Patrons-Barbiers-Coiffeurs\" of the \"du Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du District de Hull\".And, on the other part: \"La Section des Employés-Barbiers-Coiffeurs\" of the \"Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du District de Hull\", for the employers and the employees the trades concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of January 19, 1957; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance in the establishing of working conditions in the trades concerned within the territorial jurisdiction mentioned in the said petition; 1724 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N°J9 Attendu que les dispositions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre ladite requête; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1041, chapitre 163 et amendements) avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 janvier 1057.PREMIÈRE PARTIE Juridiction professionnelle 1° La juridiction professionnelle du décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations définies à l'article 2 de la présente partie.Elle s'étend également à toute personne, compagnie ou corporation qui tient ou fait tenir un salon-école organisé selon la loi de l'Enseignement spécialisé (Statuts refondus de Québec 1041, chapitre 63 et amendements) ou selon la Loi des Écoles Professionnelles (Statuts refondus de Québec 1041, chapitre 64 et amendements), ainsi qu'aux élèves qui le fréquentent.définitions Aux fins d'application des dispositions du décret, les mots et termes suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: 2° Barbier \u2014 Coiffeur pour hommes: Ces termes désignent toute'personne qui rase la barbe, coupe, tond, taille, teint ou flambe les cheveux, nettoie la téte par la méthode du shampooing, frictionne le visage, la chevelure ou le cuir chevelu et donne des massages faciaux.3° Compagnon-barbier \u2014 compagnon-coiffeur pour hommes: Ces termes désignent tout barbier ou coiffeur pour hommes qui a terminé sa période d'apprentissage, a conservé au moins 60% des points aux examens requis devant le Bureau d'Examinateurs du Comité paritaire et a obtenu dudit Comité un certificat le qualifiant comme tel.4° Artisan: Ce terme désigne toute personne exécutant pour son propre bénéfice un travail faisant l'objet de la juridiction professionnelle du décret.5° Apprenti: Ce terme désigne toute personne faisant l'apprentissage d'une ou de plusieurs des opérations faisant l'objet de la juridiction professionnelle du décret.Il comprend aussi un élève ou étudiant.6° Employé régulier: Ce terme désigne tout salarié dont les services sont retenus et rémunérés à la semaine, et dont les heures de travail hebdomadaire sont celles prescrites par le décret ou les heures régulières de travail d'un salon professionnel, si celles-ci sont moindres que celles prescrites par le décret.7* Employé temporaire, surnuméraire, remplaçant: Ces termes désignent tout salarié dont les services sont retenus et rémunérés, à l'heure, à la journée ou A commission et qui travaille une partie des heures de travail prescrites par le décret pour chaque jour ou chaque semaine, ou une partie des heures régulières de travail d'un salon professionnel, si celles-ci sont moindres que celles prescrites par le décret.8° Salon de barbier-coiffeur: Ce terme désigne un établissement où le barbier ou coiffeur pour hommes exerce sa profession.Whereab the provisions of the Act have been duly observed as regards the publication of notices; Whereas no objection has been made against the said petition; .Be it ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.\u2014 That the said petition be accepted in pursuance of the provisions of the Collective Agreejnent Act (Revised Statutes of Quebec 1041, chapter 163 and amendments) with, however, the following new provisions to be substituted for the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of January 10, 1057.PART ONE .* Professional juridiction 1.The professional juridiction of the decree extends to any person who executes or causes to be excuted one or more of the operations defined in section 2 of the present part.It extends also to any person, company or corporation who operates or causes to be operated a school-parlour organized under the Specialized Schools Act (Revised Statutes of Quebec 1041, chapter 63 and amendments) or the Trade-schools Act (Revised Statutes of Quebec, 1041, chapter 64 and amendments), and to pupils attending such a school.Definitions For the purposes of application of the present decree', the following terms shall have the meaning hereinafter given to them: 2.Barber \u2014 Men's hairdresser: These terms designate any person who shaves, cuts, clips trims, dyes or singes the hair, shampoos the head, rubs the face, the hair or scalp and gives facials (massages).3.Journeyman-barber \u2014 Men's journeyman hairdresser: These terms mean any barber or men's hairdresser who has completed his apprenticeship period, has had at least 60% of the points in the examinations before the Board of Examiners of the Parity Committee and obtained from the said Committee a certificate to that effect.4.Artisan: This term designate any person executing, for his own benefit, work included in the professional jurisdiction of the decree.5.Apprentice: This term means any person serving apprenticeship in one or more of the operations included in the professional jurisdiction of the decree.The apprentice may also be called a pupil or student.6.Regular employee: This term means any person whose services are hired and paid by the week and whose weekly hours of work are either those prescribed in the decree, or the regular working hours of a professional parlour should the latter be less than those prescribed by a decree.7.Temporary employee, occasional employee, substitute: These terms designate any person whose services are hired and paid by the hour, by the day or on a commission basis and who works part of the hours prescribed by the decree for each day or for each week, or part of the regular hours of work of a professional parlour, should the latter be less than those prescribed by the decree.8.Barber shop: This term designates an establishment where the barber or men's hairdresser plies his trade. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1725 Dispositions relatives a l'apprentissage 0° Durée:.La durée normale de l'apprentissage est de trente-six (36) mois.10° Conditions d'admission: Pour être admise à l'apprentissage, toute personne doit être figée d'au moins 16 ans et avoir terminé la 8ème année du cours élémentaire.11° Examen: A l'expiration de la durée de l'apprentissage; l'apprenti doit se présenter au Comité paritaire aux fins de subir l'examen pour l'obtention du certificat de qualification.12° Heures de travail: Les heures de travail des apprentis dans les salons professionnels sont les ml mes que celles déterminées par le décret pour les employés réguliers.Dispositions diverses 13° Aucun objet d'une valeur quelconque pouvant avoir l'effet de diminuer, les prix minima des services déterminés dans le présent décret ne peut être donné au client.14° En dehors des heures de travail, on doit faire en sorte qu'il soit facile de voir à l'intérieur des salons de barbier.15° Aucune personne ne peut exercer le métier de barbier, si elle ne détient pas un certificat de qualification émis par le bureau des examinateurs du Comité paritaire.De plus, toute personne qui détient un tel certificat doit le produire sur demande de l'inspecteur ou d'un officier du Comité paritaire.16° Dispositions générales: Dans chaque salon de barbier, il doit y avoir en service régulier et permanent une personne détenant un certificat de qualification.DEUXIÈME PARITE Dispositions \"applicables aux barbiers et coiffeurs pour hommes 101° Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du décret comprend la cité de Hull, la ville de Buckingham et un rayon de dix (10) milles de leurs limites.102° Pour les fins d'application, cette juridiction est divisée en deux (2) zones de la façon suivante: Zone I: Cité de Hull et un rayon de dix (10) milles de ses limites.Zone II: Ville de Buckingham et un rayon de dix (10) milles de ses limites.Heures de travail 103° Durée régulière: Dans la zone I, la semaine régulière de travail est de quarante-sept heures et demie (47H) réparties comme suit: v Les mardi, mercredi jeudi, vendredi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.30 p.m.Le lundi doit être chômé toute la journée axcepté, toutefois, les semaines de Noël et du Premier de l'An.Dans ce cas, les heures de travail du lundi sont de 8.00 a.m.à 6.30 p.m.Dans la zone H, la semaine régulière de travail est de quarante-neuf (49) heures réparties comme suit: Les lundi, mardi, jeudi et samedi: de 8.30 a.m.à 6.00 p.m.Les vendredi: de 8.30 a.m.à 9.00 p.m.Les mercredi: de 8.30 a.m.à midi.104° Tout travail exécuté en plus ou en dehors des heures ci-haut mentionnées par un employé régulier ou surnuméraire est considéré comme travail supplémentaire.Provisions concerning apprenticeship 9.Duration: The standard duration of apprenticeship shall be thirty-six (36) months.'t 10.Eligibility: To-be admitted to apprenticeship, candidates shall be at least 16 years old and shall have completed the 4th year of the Elementary Course.11.Examinations: At the expiration of the duration of apprenticeship, apprentices shall sit before thé Parity Committee for the certification examination.12.Hours of work: Hours of work of apprentices in professional parlors shall be the same as those determined in the decree for regular employees.Miscellaneous provisions 13.No object of any value whatever, tending to reduce the-minimum prices of the services determined m the present decree may be given to a customer.14.Outside working hours, windows or doors shall be so arranged that the inside of the parlor may be easily seen from the outside.15.No one may ply the bar be ring trade without a certificate of competency issued by the Board of Examiners of the Parity Committee.Also, any person to whom such a certificate has been issued shall produce same upon request of the inspector or of an officer of the Parity Committee.16.General provisions: In every barber shop there shall be a certificated person working regularly and permanently.PART TWO Provisions applying to barbers and men's hairdressers 101.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the present decree comprises the city of Hull, the town of Buckingham and a radius of ten (10) miles from their limits.102.For the purposes of enforcement, the said jurisdiction is divided into two (2) zones as follows: Zone I: The city of Hull and a radius of ten (10) miles from its limits.Zone II: The town of Buckingham and a radius of ten (10) miles from its limits.Hours of work 103.Regular duration: In zone I, the regular work week is forty-seven hours and a half (47J^) distributed as follows: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday: 8.00 a.m.to 6.30 p.m.No work shall be performed on Monday except, however, for Christmas and New Year's Day weeks.In such case, the hours of work on Monday are distributed between 8.00 a.m.and 6.30 p.m.In zone II, the regular work week is forty-nine (49) hours distributed as follows: Monday Tuesday, Thursday and Saturday: 8.30 a.m.to 6.00 p.m.Friday: 8.30 a.m.to 9.00 p.m.Wednesday: 8.30 a.m.to 12.00 (noon).104.All work performed outside the hours hereinabove mentioned by a regular or supernumerary employee is -considered as overtime. 1726 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N919 Toutefois, n'est pas considéré comme travail However, time taken by an employee to finish supplémentaire, toute opération exécutée par le work in progress before the expiration of the salarié pour finir le travail commencé sur un duration of work, shall not be considered as over-client avant l'expiration de la durée du travail, time.Jours chômes 105° Les jours de fêtes chômés sont les suivants: Le Premier de l'An, la Saint-Jean-Baptiste, le 1er juillet (Confédération), la fête du Travail et Noel.106° Repas: Une (1) heure doit être accordée à tout salarié pour le repas du midi et une (1) heure également pour le repas du soir, le vendredi.Salaires minima 107° Le salaire minimum pour le travail régulier est le suivant: Dans la zone 4: les barbiers-coiffeurs réguliers doivent recevoir 135.00 par semaine plus 65% des recettes de leur travail excédant (46.00 au cours de la semaine.Dane la zone II: les barbiers-coiffeurs réguliers doivent recevoir $30.00 par semaine, plus 60% des recettes de leur travail excédant $42.00 au cours de la semaine.108° Apprentis: Les apprentis doivent recevoir le salaire hebdomadaire suivant: Après le premier semestre.$12.00 Après le deuxième semestre.14.00 Après le troisième semestre.16 00 Après le quatrième semestre.18.00 109° Dans la zone I, un salarié régulier qui ne fait pas sa semaine de travail complète est payé à raison de 70% des recettes de son travail et il n'a pas droit au taux de salaire régulier de $35.00 par semaine.Le même pourcentage s'applique aux salariés surnuméraires.110° Aucun employeur n'a le droit de réduire le salaire d'un salarié recevant plus que les minima ci-haut mentionnés lors de l'entrée en vigueur du présent décret.Vacances payées 111° Tout salarié doit recevoir chaque année un.montant équivalent à 2% du salaire de base gagné, à titre de rémunération pour ses vacances.Si un salarié quitte le service de son employeur avant d'avoir complété douze (12) mois de service, il doit recevoir quand même, en tel cas, une rémunération équivalente à 2% du salaire de base gagné à date.Paix minima des services 112° Les employeurs professionnels, les artisans et les salariés doivent charger au public, les prix minima suivante pour les services ci-dessous énumérés: Zones I II Barbe.$0.45 $0.40 Coupe de cheveux: Pour adultes des deux sexes.0.75 0.65 Pour enfants de moins de 14 Holidays 105.The following shall be days kept as holidays: New Year's Day, St.John the Baptist Day, July 1 (Confederation Day), Labour Day and Christmas Day.106.Meals: Every employee is entitled to one (1) hour for his noon meal and one (1) hour for the evening meal on Friday.Minimum wages 107.The minimum wages for regular work are as follows: * In zone I: regular barbers and hairdressers shall receive $35.00 per week, plus 65% of the receipts of their work exceeding $4GltX) during the week.In zone II: regular barbers shall be paid $30.00 per week, plus 60% of the receipts of their work exceeding $42.00 during the week.108.Apprentice*: Apprentices shall receive the following weekly wages: After six months.$12.00 After twelve months.14.00 After eighteen months.16.00 After twenty-four months.18.00 109.In zone I, a regular employee not work- ' ing the entire week shall be paid 70% of the receipts of his work and shall not be entitled to the weekly regular rate of $35.00.The same percentage applies to supernumerary employees (extras).110.No employer has the right to reduce the wages of an employee receiving more than the minimum rates hereinabove mentioned at the time of the coming into force of the present decree.Vacation with pay 111.Every employee shall receive, each year, as vacation pay, an amount equivalent to 2% of the basic wages earned.In the event of an employee leaving his employer before the completion of 12 months service, he is entitled to a remuneration equivalent to 2% of the basic wages earned to date.Minimum prices of services 112.Professional employers, artisans and employees .shall charge the following minimum prices for the services hereinafter mentioned: ans.0.50 0.40 Coupe de cheveux en brosse: Pour adultes.1.00 0.90 Pour enfants de moins de 14 ans.,.0.70 0.65 Flambage des cheveux.0.25 0.25 Shampooing.0.50 0.35 Massage.0.75 0.50 Tonique ou lotion.0.25 0.25 Aiguisage de rasoir.0.50 0.35 Shave.Haircut: Male and female adults.Children under 14 years of age.Brushcut: Adults.Children under 14 years of # age.'.Singeing of the hair.Shampoo.Massage.Tonic, lotion.Razor setting.Zones I II $0.45 $0.40 0.75 0.65 0.50 0.40 1.00 0.90 0.70 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.65 0.25 0.35 0.50 0.25 0.35 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1727 113 Aucun objet d'une valeur quelconque 113.No object of any value whatsoever may pouvant servir à abaisser les taux ci-haut énu- be given to a customer for the purpose of reduc- mérés ne peut être donné au client.ing the rates hereinabove enumerated.114° Il est interdit d'offrir gratuitement des 114.No one shall offer, without charge, servi-services faisant l'objet du présent décret ou de ces regulated by the present decree or give what .donner quelque objet que ce soit comme prime, article soever as a premium in order to attract en vue d'attirer la clientèle ou ayant pour effet customers or reduce the rates ordinarily charged de réduire les taux des services ordinairement in such parlors, chargés dans ces salons.Prorata des apprentis Prorata of apprentices 115° Dans aucun salon, il n'est permis d'à- 115.No parlour is permitted to have more voir plus d'un (1) apprenti.¦ than one (1) apprentice.116° Le présent décret abroge le décret nu- 116.The present decree repeals the decree méro 2246 du 27 août 1941 et tous ses amende- number 2246 of August 27, 1941 and all its ments.amendments.117° Lors de la ratification de la présente 117! At the time of ratification of the preconvention, le Comité paritaire existant, formé sent agreement, the existing Parity Committee, pour surveiller l'application du décret antérieur formed to administer the former decree in the dans la juridiction territoriale déterminée par territorial jurisdiction determined by the pre-la présente convention, demeure en fonction et sent agreement, remains in office and administers surveille la mise en execution du présent décret the present decree until the formation of a new jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé, committee.Such new committee succeeds the Ce nouveau comité succède à l'ancien et est former committee and is vested with all the investi de tous les actifs et droits dudit comité; assets and rights of the said committee; it also il assume également toutes les dettes -de l'an- assumes all the liabilities of the said former com-cien comité, en vertu dudit décret antérieur.mittee incurred under the said previous decree.Durée du décret Duration of the decree 118° Le décret est valable à compter du jour 118.The decree comes into force on the date de sa publication dans la Gazette officielle de Qui- of its publication in the Quebec Official Gazette bec et demeure en vigueur jusqu'au 1er septem- and remains in force until September 1, 1958.bre 1958.Il se renouvelle automatiquement It then renews itself automatically from year d'année en année par la suite, à moins que l'une to year unless one of the contracting parties des parties contractantes ne donne à l'autre notifies the other party, in writting, to the con- partie un avis écrit à ce contraire dans un délai trary within the period extending from the 3ui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni sixtieth (60) to the thirtieth (30) day before the e moins de trente (30) jours avant l'expiration expiration of any subsequent year.Such a notice de toute année subséquente.Un tel avis doit must also be sent to the Minister of Labour, également être adressé au Ministre du Travail.L.DÊSILETS, L.DÊSILETS, 47715-o Greffier du Conseil Exécutif.47715-0 Clerk of the Executive Council.Avis divers Miscellaneous Notices (P.G.2039-50) (A.G.2039-50) Avis est donné que, sur la recommandation Notice is hereby given that, on the recommen-de l'Assistant-procureur général, l'honorable Se- dation of the Deputy Attorney General, the crétaire de la province a, le vingt-cinq avril 1958, Honourable the Provincial Secretary has, on approuvé les règlements de \"L'Association Spor- April twenty-first, 1958, approved the by-laws tive de la Rive Nord\", et ce, conformément aux of \"L'Association Sportive de la Rive Nord\", dispositions de l'article 225 de la Loi des com- and such pursuant to the provisions of section pagnies de Québec.225 of the Quebec Companies' Act.Donné au bureau du Secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary, le vingt-six avril 1958.on April twenty-sixth, 1958.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHESI, 47699-o JEAN BRUCHESI.47699 Under Secretary of the Province.AVIS PUBLIC Regie provinciale de l'électricité Tarifs pour vente et distribution du gaz Avis est par les présentes donné que la \"Corporation de Gaz Naturel du Québec\", distributeur aux termes de la Loi concernant la vente et la distribution du gaz, (5-6 Elizabeth n, 1956-57, chapitre 54) a, par sa requête en date du 30 avril 1958, demandé à la Régie Provinciale de l'Électricité d'approuver de nouveaux tarifs pour la vente et la distribution du gaz, devant PUBLIC NOTICE Provincial electricity board Rates for the sale and distribution of gas.Notice is hereby given that \"Quebec Natural Gas Corporation\", a distributor as defined by the Act respecting the sale and distribution of gas (5-6 Elizabeth U, 1956-57, chapter 54), has, by its petition dated April 30th, 1958, requested the Provincial Electricity Board to approve new rates for the sale and distribution of gas, effective June 1st, 1958. 1728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1958, Tome 90, N° 19 prendre effet après le 1er juin 1958.Tout intéressé peut obtenir copie des tarifs proposés en s'adressant au soussigné.Toute personne désirant soumettre des représentations sur le sujet devra en aviser le soussigné par écrit avant le 21 mai 1958.Par Ordre: Le Secrétaire, J.-A.MORIN.132 rue St-.lueque.s Ouest, Montréal l.P.Q.47705-o (P.G.11118-58) Arthuk Blouin (Limitée) Règlement N° 3 réduisant le nombre des directeurs de quatre à trois \"L'article N° 11 du règlement N° 1 de la compagnie est abrogé en son entier et remplacé par le suivant: \"Jusqu'à ce qu'il soit autrement pourvu, les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de trois directeurs.\" \" Vraie copie certifiée.Sherbrooke, le 26 mars 1958.^^ Sccrét&irc* 47706-o .LUCIENNE BIRON.(P.G.13443-57) La Compagnie Canadienne du Théâtre-Club Ltée The Canadian Company op Theatre-Club Ltd.Règlement N\" 5 Qu'il soit et il est par les présentes décrété comme règlement N° 5 de la compagnie que le nombre des directeurs soit et il est par les présentes augmenté de trois à six.Certifié vraie copie du règlement N° 5 de \"La Canadienne du Théfttre-Club Ltée \u2014 The Canadian Company of Theatre-Club Ltd.\" adopté par les directeurs à une assemblée tenue à Montréal le 8 novembre 1957 et ratifié à une assemblée d'actionnaires tenue à Montréal le même jour.Le Secrétaire, 47708-o SUZANNE LEFEBVRE.(P.G.10820-58) Migdal Construction Ltd.Règlement N° 28 Que le nombre des directeurs de la compagnie \"Migdal Construction Ltd.\" soit augmenté de trois à quatre; et Que le procureur de la compagnie, Me S.Greenblatt, soit autorisé à prendre les procédures nécessaires afin de valider ledit règlement.Certifié vraie copie.Le Secrétaire-trésorier, 47709 ASHER RYDEL.(P.G.12410-54) Super Service Forwarding Ltd.Règlement A (diminuant le bureau de direction de quatre à trois) Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme le règlement A de \"Super Service Forwarding Ltd.\", ce qui suit: 1° Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau formé de trois directeurs, ^All concerned may obtain from the undersigned copies of the proposed new schedule of rates.Any person wishing to submit representations respecting this matter, shall notify the undersigned, in writing, before May 21st, 1958.By Order: J.-A.MORIN, Secretary.132 St.James St., West, Montreal 1, P.Q.47705-o (A.G.11118-58) Arthuk Blouin (Limitée) By-law No.3 decreasing the number of directors from four to three \"Article No.11 of by-law No.1 of the company is repealed in its entirely and replaced by the following: \"Until it has been otherwise provided for, the affairs of the company shall be managed by a board of three directors.\" \" Certified true copy.Sherbrooke, March 26, 1958.LUCIENNE BIRON, 47706 Secretary.(A.G.13443-57) La Compagnie Canadienne du Théâtre-Club Ltée The Canadian Company op Theatre-Club Ltd.By-law No.5 Be it and it is hereby enacted as by-law No.5 of the company that the number of the directors of the company be and is hereby increased from three (3) to six (6).Certified true copy of by-law No.5 of \"La Compagnie Canadienne du Théâtre-Club Ltée \u2014 The Canadian Company of Theatre-Club Ltd.\" adopted by the directors at a meeting held at Montreal on November 8th, 1957 and ratified at a shareholders' meeting held at Montreal on the same day.SUZANNE LEFEBVRE, 47708 Secretary.(A.G.10820-58) Migdal Construction Ltd.By-law No.23 That the number of Directors of \"Migdal Construction Ltd.\" be increased from three to four; and That the Company's attorney, Mtre.S.Greenblatt, be authorized to make the necessary proceedings to validate the said By-Law.Certified a true copy.ASHER RYDEL, 47709-o Secretary-Treasurer.(A.G.12410-54) Super Service Forwarding Ltd.By-law A (decreasing the Board of Directors from four to three) Be it enacted and it is hereby enacted as By-law A of \"Super Service Forwarding Ltd.\", as follows: 1.The affairs of the Company shall be managed by a Board of three directors, each of whom QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1729 dont chacun, au moment de son élection et pendant la durée de sa fonction, sera un actionnaire de la compagnie au montant d'au moins une action et n'aura pas d'arrérages relativement à tout appel sur icelle.2° Deux directeurs formeront quorum pour la transaction des affaires.Aucune résolution ou action du bureau de direction ne sera adoptée ou exécuter à moins qu'elle soit confirmé par au moins deux directeurs.3° Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet au présent règlement.Décrété ce 19e jour de février 1958.Certifié vraie copie., (Sceau) Le Secrétaire, 47710 BRUCE SMITH.at the time of his election and throughout the term of his office shall be a shareholder in the Company to the amount of at least one share and not in arrears in respect of any call thereon.2.Two directors shall form a quorum for the transaction of business.No resolution or action of the Board of Directors shall be adopted or effected unless concurred in by at least two directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 19th day of February, 1958.Certified a true copy.(Seal) BRUCE SMITH, 47710-o Secretary.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse des Jeunes Travailleurs de Lachute\", en date du 27 février 1958, dont le siège social est situé à Lachute, comté d'Argenteuil, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le vingt-huit avril 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 47722-0 JEAN BRUCHESI.(P.G.7045-45) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant procureur général, l'Honorable Secrétaire de la province a approuvé, en date du 5 mai 1958, le règlement numéro \"A\" de \"Occupational Therapy & Rehabilitation Centre\", tel qu'adopté à l'assemblée annuelle tenue le 26 février 1958, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 6 mai 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 47723 JEAN BRUCHESI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse des Jeunes Travailleurs de Lachute\" under date of February 27, 1958, whereof the head office is at Lachute, county of Argenteuil, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-eighth day of April, 1958.JEAN BRUCHESI, 47722 Under Secretary of the Province.(A.G.7045-45) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-Law number \"A\" of the \"Occupational Therapy & Rehabilitation Centre\", has adopted ai the annual meeting held on February 26th, 195», has been approved by the Honourable the Provincial Secretary on the 5th day of May, 1958, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of May, 1958.JEAN BRUCHESI, 47723-o Under Secretary of the Province.Province de Québec Syndics de la paroisse de Saint-Jérôme de Lac Saint-Jean Avis de rachat d'obligations Avis est donné, par les présentes, qu'aux termes de l'acte de fiducie par les Syndics de la paroisse de Saint-Jérôme de Lac Saint-Jean en faveur de la Société Nationale de Fiducie, exécuté devant Me Oscar Hamel, notaire, le 23 août 1939, lesdits Syndics rachèteront par anticipation, le 1er juillet 1958, au prix de 100% de leur valeur nominale et l'intérêt couru, $5,000.00 d'obligations faisant partie de leur émission de $153,500.00, savoir: 3x1000 \u2014 Nos AM-30, 59 et 79 4x500 \u2014 Nos AD-44, 66, 85 et 88.Les porteurs des obligations ci-dessus mentionnées.devront, le 1er juillet 1958, présenter lesdites obligations pour paiement à la Banque Canadienne Nationale, à Saint-Jérôme, Chicoutimi, Québec, ou Montréal, avec le coupon d'intérêt du 1er juillet 1958 et les coupons subséquents.Province of Quebec Trustees of the parish of Saint Jerome of Lake St.John Notice of redemption Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Trust Deed by the Trustees of the parish of Saint Jerome of Lake Saint John in favor of the Société Nationale de Fiducie, passed before notary Oscar Hamel, on August the 23rd, 1939, said Trustees will redeem before maturity, on the first day of July 1958, at price of 100% at par and accrued interest, $5,000.00 principal amount of bonds being part of their issue of $153,500.00, viz: 3x1000 \u2014 Nos AM-30, 59 et 79 4x500 \u2014 Nos AD-44, 66, 85 et 88.The holders of the above mentioned bonds shall, on the first of July 1958, present the said bonds for payment at the Banque Canadienne Nationale, at Saint Jerome, Chicoutimi.Quebec or Montreal, with interest coupon maturing on the first of July 1958, and following coupons.\\ 1730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 Lesdites obligations cesseront de porter intérêt à compter du 1er juillet 1958.Montréal, ce 6 mai 1958.SOCIÉTÉ NATIONALE DE FIDUCD3 Fiduciaire (Trustee) Directeur général, H.OTJTMET.41 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal 1.47724-o Province de Québec Ville Saint-Martin Règlement N° 67 règlement concernant la durée du terme d'office du maire et des échevins Séance régulière et mensuelle du Conseil de la Ville de Saint-Martin, comté de Laval, tenue au lieu et heure ordinaires des séances de cedit Conseil, lundi le troisième jour de février 1958, 2 l'Hôtel-de-Ville, 1520 rue Principale, Ville de Saint-Martin, comté de Laval, 8.30 heures p.m.A laquelle sont présents: Son honneur le Maire Louis Jarry, et Messieurs les Échevins Emile Lavoie, Albert Page, Henri Duplessis Jr., Bona Major, absent monsieur l'Échevin Réal Roussin, formant quorum des membres de ce Conseil.La séance s'ouvre sous la présidence du Maire Louis Jarry.Proposé par monsieur l'échevin Emile Lavoie, Secondé par monsieur l'échevin Bona Major.Et résolu: Attendu que le conseil peut, par règlement, fixer à trois (3) ans, à compter de l'élection suivante, la durée de la fonction du Maire et des échevins; Attendu qu'il y aurait avantage pour la bonne administration de Ville Saint-Martin, que la durée du terme du maire et des échevins, soit prolongée à trois (3) ans; Qu'il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la ville, et il est, par le présent règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la loi, comme suit: Article 1° A compter de l'élection qui aura lieu après l'entrée en vigueur du présent règlement, la durée des fonctions du maire et des échevins dans Ville Saint-Martin, soit et est fixée à trois (3) ans.Article 2° Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, et en autant qu'il aura été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et ensuite publié dans la Gazette officielle de Québec.Maire de la Ville Saint-Martin, ¦(Signé) LOUIS JARRY.Secrétaire-trésorier de la Ville Saint-Martin, (Signé) ALPHONSE GOYER.Vraie copie.Le Secrétaire-trésorier, 47725-0 ALPHONSE GOYER.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le , troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif des Producteurs de Bleuets de St-Eugène d'Argen-tenay\", en date du 20 mars 1958, dont le siège social est situé à St-Eugène d'Argentenay, comté de Roberval, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.The said bonds will cease to bear interest on and from the first of July, 1958.Montreal, this 6th of May, 1958.SOCIÉTÉ NATIONALE DE FIDUCIE Fiduciaire (Trustee) Directeur général, H.OUIMET.41 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal 1.47724-o Province of Quebec Town of Saint-Martin By-law No.67 by-law concerning the duration of the term of Office of the Mayor and aldermen.Regular and monthly meeting of the Council of the Town of Saint-Martin, county of Laval, held at the ordinary time and place of the meetings of the said Council, Monday, the third day of February, 1958, at the Town Hall, 1520 Principal Street, Town of Saint-Martin, county of Laval, 8.30 p.m.Were present: His Honour, the Mayor Louis Jarry, and Messrs.the Aldermen Emile Lavoie, Albert Page, Henri Duplessis Jr., Bona Major, was absent Alderman Real Roussin, forming quorum of the members of this Council.The meeting opens under the presidency of the Mayor, Louis Jarry.Proposed by Alderman, Emile Lavoie, Seconded by Alderman, Bona Major.And resolved: Whereas the Council may, by by-law, fix at three (3) years, from and after the following election, the duration of the functions of the Mayor and Aldermen; Whereas it would be to the advantage of the good management of the Town of Saint-Martin, that the duration of the term of the Mayor and Aldermen be prolonged to three (3) years; That it be enacted and ordained by a bylaw of the Town Council, and it is, by the present by-law, enacted and ordained, subject to all the approbations required by law, as follows: Section 1.From and after the election which shall take place after the entry into force of the present by-law, the duration of the functions of the Mayor and aldermen in the.Town of Saint-Martin, be and is fixed to three (3) years.Section 2.The present by-law shall enter into force according to law, and inasmuch as it shall have been approved by the Lieutenant-Governor in Council and following publication in the Quebec Official Gazette.(Signed) LOUIS JARRY, Mayor of the Town of Saint-Martin.(Signed) ALPHONSE GOYER, Secretary-Treasurer of the Town of Saint-Martin.True copy.ALPHONSE GOYER, 47725 .Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif des Producteurs de Bleuets de St-Eugène d'Argentenay\", under date March 20, 1958, whereof the head office is at St.Eugène d'Argentenay, county of Roberval, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1731 Donné au bureau du Secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary, le vingt-huit avril 1958.this twenty-eighth day of April, 1958.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHESI, 47726-0 JEAN BRUCHESI.47726 Under Secretary of the Province.(P.G.13844-57) Greenland Realties Ltd.Règlement N° 28 1.Le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de trois (3) à quatre (4), de manière que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de quatre (4) directeurs.2.Trois (3) directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction; 3.Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet au présent règlement.Certifiée vraie copie du règlement No 23, te) que décrété par les directeurs et approuvé par les actionnaires de la compagnie le 7 janvier 1958.47737 Le Secrétaire, H.GREENSPOON.(P.G.11406-55) Les Entreprises Ste-Marie Inc.Ste.Marie Enterprises Inc.Règlement N° B.2 \"Que le règlement no.4A), tel que modifié par le règlement N° B-l, soit de nouveau modifié pour réduire de 7 à 3 le nombre des directeurs de la compagnie, de façon que ledit règlement N° 4, paragraphe \"a\", se lise à l'avenir comme suit: Règlement N° 4, Directeurs, a) Nombre \u2014 Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de trois directeurs.H est proposé par monsieur Henri de Cazes, secondé par monsieur Joseph-Edouard Gagnon et unanimement résolu que le règlement N° B-2 soit et il est par les présentes adopté à l'unanimité, sujet à l'approbation des actionnaires\".Québec, ce 5 mai 1958.Certifié vraie copie (Sceau) Le Secrétaire, 47754-0 RENÉ C.FALARDEAU.(P.G.11409-55) Drainage Ste-Marie Inc.Ste.Marie Drainage Inc.Règlement N° B-2 \"Que le règlement N° 4A), tel que modifié par le règlement N° B-l, soit de nouveau modifié pour réduire de 7 à 3 le nombre des directeurs de la compagnie, de façon que ledit règlement N° 4, paragraph \"o\", se lise à l'avenir comme suit: Règlement N° 4, Directeurs.a) Nombre:\u2014-Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de trois directeurs.Il est proposé par monsieur Henri de Cazes, secondé par monsieur Joseph-Edouard Gagnon et unanimement résolu que le règlement N° B-2, soit et il est par les présentes adopté à l'unanimité, sujet à l'approbation des actionnaires.\" Québec, ce 5 mai 1958.Certifié vraie copie (Sceau) Le Secrétaire, 47755k) RENÉ C.FALARDEAU.(A.G.13844-57) Greenland Realties Ltd.By-law No.28 1.The number of directors of the company is increased from three (3) to four (4) in number so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of four (4) directors.2.Three (3) Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors; 3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-laws.Certified a true copy of by-law No.23, as enacted by the directors and approved by the shareholders of the company on January 7th, 1958.H.GREENSPOON, 47737-0 Secretary.(A.G.11406-55) Les Entreprises Ste-Marie Inc.Ste.Marie Enterprises Inc.By4aw No.B.2 \"That by-law No.4A) as amended by by-law No.B-l, be amended once again to decrease from 7 to 3 the number of directors of the Company, in order that said by-law No.4, paragraph \"a\", shall read hereafter as follows: By-law No.4, Directors, a) Number \u2014 The affairs of the company shall be managed by a board of three directors.On motion by Mr.Henri de Cazes, seconded by Mr.Joseph Edouard Gagnon it has been unanimously resolved that By-law No.B-2 be and it is hereby adopted unanimously, subject to confirmation by shareholders\".Quebec, May 5, 1958.Certified true copy.(Seal) RENÉ C.FALARDEAU, 47754 Secretary.(A.G.11409-55) Drainage Ste-Marie Inc.Ste.Marie Drainage Inc.By-law No.B-2 \"That by-law No.4A), as amended by the by-law No.B-l, be again amended to reduce from 7 to 3 the number of the Directors of the company, so that the said by-law No.4, paragraph \"a\", in future, shall read as follows: By-law No.4, Directors a) Number:\u2014The affairs of the company shall be administrated by a Board of three Directors.It is proposed by Mr.Henri de Cazes, seconded by Mr.Joseph-Edouard Gagnon and resojved ' unanimously that by-law No.B-2 be and it is hereby by these presents unanimously adopted, subject to the approval of its shareholders.' Quebec, May 5,1958.Certified true copy.(Seal) RENÉ C.FALARDEAU, 47755 Secretary. 1732 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1958, Tome 90, N° 19 Chartes \u2014 Abandon de L.V.Textiles Limited Conformément aux dispositions de la Loi des Compagnies de Québec, la compagnie \"L.V.Textiles Limited\" donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Procureur Fénéral et au Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Affaires Municipales pour lui demander permission d'abandonner sa charte à partir d'une date qu'il leur plaira de fixer.Montréal, 29 avril 1958.L.V.TEXTILES LIMITED, Par le Secrétaire, THÉRÈSE VENDITTI.a/s R.L.Bercovitch, avocat, 1117, rue Stè-Catherine ouest, Montréal, Québec.47700-o The American Advertising Agency Limited Avis est, par les présentes, donné que \"The American Advertising Agency Limited\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce vingt-troisième jour d'avril 1958.Le Secrétaire, 47701 J.B.BUCKLEY.The Page Fence and Wire Products Company, Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie \"The Page Fence and Wire Products Company, Limited\" constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de la province de Québec et ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'addressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 5e jour d'octobre 1958.Le Secrétaire, 47727-0 THOMAS C.CAMP.La compagnie \"Best's Ladies Wear Inc.\".donne, par les présentes, avis qu'elle demandera au Procureur général, province de Québec, l'acceptation de l'abandon de sa charte.Montréal, 7 mai 1958.Le Procureur de Best's Ladies Wear Inc., 47756 DAVID LITNER.Compagnies dissoutes (P.G.14154-57) Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsibilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Corporate Services Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 juin 1954.Charters \u2014 Surrender of .L.V.Textiles Limited \u2022 Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"L.V.Textiles Limited\" hereby gives notice that it will make application to the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce for acceptance of the surrender of its charter on and from a date to be fixed by them.Montreal, April 29th., 1958.L.V.TEXTILES LIMITED, Per THÉRÈSE VENDITTI, Secretary.c/o R.L.Bercovitch, advocate, 1117 St.Catherine Street West, Montreal, Que.47700-o The American Advertising Agency Limited Notice is hereby given that \"The American Advertising Agency Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this twenty-third day of April, 1958.j.B.BUCKLEY, 47701-o Secretary.The Page Fence and Wire Products Company, Limited Notice is hereby given that ''The Page Fence and Wire Products Company, Limited\", a company incorporated under the Quebec Companies' Act and having its Head Office in the city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, this 5th day of May, 1958.THOMAS C.CAMP, 47727-o Secretary.\"Best's Ladies Wear Inc.\", hereby gives notice that it will make application to the Attorney General, Province of Quebec, for acceptance of the surrender of its Charter.Montreal, May 7th, 1958.DAVID LITNER, Attorney for 47756-0 Best's Ladies Wear Inc.Companies Dissolved (A.G.14154-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Corporate Services Inc.\", incorporated by letters patent dated June 4, 1954. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1958, Vol.90, No.19 1733 Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur généra], le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.10025-58) Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Four Grand Investments Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 mars 1953.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(P.G.13245-57) Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsibilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Giroux Motor Sales Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 octobre 1942.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.13362-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Hibbard Motors Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 octobre 1945./ Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.13885-57) Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"L'Edifice Chevalier, Limitée\", constituée eh corporation par lettres patentes en date du 14 octobre 1941.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of Mav, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10025-58) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Four Grand Investments Ltd.\", incorporated by letters patent dated March 25, 1953.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office, of the Attorney General, this first day of May, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13245-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Giroux' Motor Sales Ltd.\", incorporated by letters patent dated October 30, 1942.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13362-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Hibbard Motors Ltd.\", incorporated by letters patent dated October 26, 1945.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13885-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"L'Édifice Chevalier, Limitée\", incorporated by letters patent dated October 14, 1941.Notice is also given that from and after April thirtieth, 1958, the said company has been dissolved.- 1734 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N* 19 Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 47607-o P.FRENETTE.(P.G.13009-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la chai te de la compagnie \"Notre Maison (Compagnie Limitée)\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 février 1955.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.13913-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Simard, Chevalier & Choyer Limitée\", constituée en corporation par lettres pates en date du 30 juin 1933.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.v Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-o P.FRENETTE.(P.G.13740-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsibility décrétée .par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Western Taxi Association Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 novembre 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du trente avril 1958, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 47697-0 P.FRENETTE.(Sec.P.1591-19) Breakeyville Stores Co.Ltd.Avis est donné que \"Breakeyville Stores Co.Ltd.\", une compagnie constituée en corporation sous le nom originaire de \"The Chaudière Mill Store Company Limited\" par lettres patentes en date du 6 octobre 1911 avec siège social à Breakeyville, Que, a été dissoute à compter du 10e jour d'avril 1958, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, S.R.Q.1941, chapitre 278.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 18 avril 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 47702 JEAN BRUCHESI.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13009-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to \"the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Notre Maison (Compagnie Limitée)\", incorporated by letters patent dated February 22, 1955.Notice is also given that from and after April thirtieth 1958 the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13913-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Simard, Chevalier & Choyer Limitée\", incorporated by letters patent dated June thirtieth, 1933.Notice is also given that from and after April thirtieth 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13740-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Western Taxi Association Limited\", incorporated by letters patent dated November 26, 1946.Notice is also given that from and after April thirtieth 1958, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May 1958.P.FRENETTE, 47697 Acting Deputy Attorney General.(P.Sec.1591-19) Breakeyville Stores Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Breakeyville Stores Co.Ltd.\", a company incorporated under the original name of \"The Chaudière Mill Store Company Limited\" by letters patent dated October 6th, 1911, with head office at Breakeyville, Que, has been dissolved on and from the 10th day of April, 1958, pursuant to the prosi-sions of the Winding-up Act, R.S.Q.1941, chapter 278.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of April, 1958.JEAN BRUCHESI, 47702-o Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No> 19 1735 Département de l'Instruction Publique N° 356-58.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Duhamel-Ouest, dans le comté de Témiscamingue, à la municipalité scolaire de Ville-Marie, dans le même comté.Québec, le 28 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47692-18-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 863-54.II a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 24 avril 1958, de détacher de la municipalité scolaire de Ste-Anne-de-Chicoutimi paroisse, dans le comté de Chicoutimi, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de la ville de Chicoutimi-Nord, dans le même comté.Ce territoire comprend les lots 12 à 16 inclusivement et toutes leurs subdivisions du rang I; les lots 34 à 38 aussi inclusivement et leurs subdivisions du rang II ainsi que les lots 28 à 31 inclusivement du rang III, tous des plan et livre de renvoi officiels du canton Tremblay.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Québec, le 1er mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique.47716-0 O.J.DESAULNIERS.N° 104-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 24 avril 1958, d'annexer à la municipalité scolaire de < Cla-pham, dans le comté de Pontiac, le territoire ci-dessous décrit, du canton Alleyn, lequel n'est pas encore organisé au point de vue scolaire^ rang I lots 32 à 49 inclusivement; rang II, lots 31 à 49 inclusivement, rang III, lots 27 à 49 inclusivement.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Québec, le 1er mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47716-0 O.J.DESAULNIERS.N° 1282-57.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 24 avril 1958, de détacher de la municipalité scolaire de Bon-secours, dans le comté de Shefford, les lots 1035, 1036 et 1037 du cadastre officiel du danton Stukely, pour les annexer à la municipalité scolaire du village de Lawrence ville, dans le même comté.Québec, le 2 mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47716-0 O.J.DESAULNIERS.N° 1303-57.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 24 avril 1958, 10 d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Ste-Marie-Madeleine paroisse, dans le comté de St-Hyacinthe, à celui de la municipalité scolaire de Ste-Marie-Madeleine village, dans le même comté.2° de changer le nom de la municipalité scolaire de Ste-Marie-Madeleine village, dans le comté de St-Hyacinthe, en celui Department of Education No.356-58.Application is made to annex the present territory of the School Municipality of Duhamel-West, in the county of Témiscamingue, to the School Municipality of Ville-Marie, in the same county.Quebec,'April 28,1958.O.J.DESAULNIERS, 47692-18-2 Superintendent of Education.No.863-54.His a Honour, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated April 24, 1958, to detach from the School Municipality of Ste.Anne-de-Chicoutimi parish, in the County of Chicoutimi, the territory nerein-under described in order that it be annexed to the School Municipality of the Town of Chicou-timi-North, in the same county.This territory comprises lots 12 to 16 inclusive and all the subdivisions thereof in range I; lots 34 to 38 also inclusive and subdivisions thereof in range II including lots 28 to 31 inclusive of range III, all of the official plan and book of reference of the township of Tremblay.This change shall take effect on July 1st, 1958.Quebec, May 1st, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47716 Superintendent of Education.No.104-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order In Council dated April 24, 1958, to annex to the school municipality of Clapham, in the county of Pontiac, the territory hereinunder described, of the township Of Alleyn, which is not as yet organised for school purposes; range I, lots 32 to 49 inclusive; range II, lots 31 to 49 inclusive, range III, lots 27 to 49 inclusive.This change shall take effect on July 1st, 1958.Quebec, May 1st, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47716 Superintendent of Education.No.1282-57.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated April 24, 1958, has been pleased to detach from the school municipality of Bonsecours, in the county of Shefford, lots 1035, 1036 and 1037 of the official cadaster of the township of Stukely, to annex them to the school municipality of the village of Lawrenceville, in the same dounty.Quebec, May 2nd, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47716 Superintendent of Education.No.1303-57v His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated April 24, 1958, has been pleased 1.To annex the present territory of the school municipality of Ste-Marie-Madeleine, parish, in the county of St-Hyacinthe, to that of the school municipality of Ste-Marie-Madeleine village, in the same county.2.To change the name of the school municipality of Ste-Marie-Madeleine, village, in the county of 1736 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 de \"La municipalité scolaire de Ste-Marie-Madeleine, dans le comté de St-Hyacinthe\".Ces changements prendront effet au 1er juillet 1968.Québec, le 30 avril 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47716-0 O.J.DESAULNIERS.N° 311-58.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire du village de Boucherville, dans le comté de Chambly, en celui de \"La municipalité scolaire de Boucherville, dans le comté de Chambly.\" Québec, le 2 mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47717-19-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1236-53.Demande est faite de détacher de la munici- Çilité scolaire de Brébeuf, dans le comté dé errebonne, le lot 29 du rang VIII du canton Arundel, pour l'annexer à la municipalité scolaire d'Huberdeau, dans le comté d'Argenteuil.Québec, le 1er mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47718-19-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 807-57.Demande est faite 1° d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Ste-Anne-de-la-Pérade paroisse, dans le comté de Chain-plain, à celui de la municipalité scolaire de Ste-Anne-de-la-Pérade village, même comté.2° Qu'à partir du 1er juillet 1958, le nom de la municipalité scolaire de Ste-Anne-de-la-Pérade village, dans le comté de Champlain, soit changé en celui de \"La municipalité scolaire de Ste-Anne-de-la-Pérade, dans le comté de Champlain.\" Québec, le 1er mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47719-19-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 319-58.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Pierre-de-Véronne dans le comté de Missisquoi, les lots 19-33 et 203 du cadastre officiel du canton Stanbridge, pour les annexer à la municipalité scolaire de St-Philippe-de-Philipsburg, même comté.Québec, le 6 mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47721-19-2-0 O.J.DESAULNIERS.N° 356-58.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Duhamel-Ouest, dans le comté de Témiscamingue, à celui de la municipalité scolaire de Ville-Marie, dans le même comté.Québec, le 7 mai 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 47758-19-2-o O.J.DESAULNIERS.Mines Canada \u2014 Province de Québec avis de révocation de la vente de terrains miniers situés dans le canton de Beauchastel Avis est par la présente donné que le Ministre des Mines, en vertu des dispositions de l'article St-Hyacinthe, into that of \"The School Municipality of Ste-Marie-Madeleine, in the county of St-Hyacinthe\".These changes will take effect on July 1st, 1958.Quebec, April 30, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47716 .Superintendent of Education.No.311-58.Application is made to change the name of the school municipality of the village of Boucherville, in the county of Chambly, to that of \"The school municipality of Boucherville, in the county of Chambly.\" Quebec, May 2, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47717-19-2 Superintendent of Education.No.1236-53.Application is made to detach from the school municipality of Brébeuf, in the county of Terrebonne, lot 29, range VIII of the township of Arundel, in order that it be annexed to the school municipality of Huberdeau, in the county of Argcnteuil.Quebec, May 1st, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47718-19-2 Superintendent of Education.No.807-57.Application is made 1.to annex the present territory of the school municipality of Ste.Anne-de-la-Pérade parish, in the county of Champlain, to that of the school municipality of Ste.Anne-de-la-Pérade village, same county.2.That from and after July 1st, 1958, the name of the school municipality of Ste.Anne-de-la-Pérade village, in the county of Champlain, be changed to that of \"The school municipality of Ste.Anne-de-la-Pérade, in the county of Champlain.\" Quebec, May 1st, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47719-19-2 Superintendent of Education.No.319-58.Application is made to detach from the school municipality of St-Pierre-de-Véronne, in the county of Missisquoi, lots 19-33 and 203 of the official cadaster of the township of Stanbridge, to annex them to the school municipality of St-Philippe-de-Philipsburg, same county.Quebec, May.6, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47721-19-2 Superintendent of Education.No.356-58.Application is made to annex the present territory of the School Municipality of Duhamel-West, in the county of Témiscamingue, to that of the School Municipality of Ville-Marie, in the same county.Quebec, Mav 7, 1958.O.J.DESAULNIERS, 47758-19-2 Superintendent of Education.Mines Canada \u2014 Province of Quebec Notice of cancellation of the sale \u2022 of mining lands situated in Beauchastel townbhip Notice is hereby given that the Minister of Mines, pursuant to the dispositions of section 49 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1737 49 de la Loi des mines, et pour défaut d'accomplissement des conditions requises par la loi, révoquera la vente des terrains miniers ci-dessous décrits, après la publication du présent avis dans deux numéros de la Gazette officielle de Québec et une fois dans un journal français et dans un journal anglais de la cité de Montréal et après expédition dudit avis par lettre recommandée à l'acquéreur, à son adresse connue.Ces terrains miniers sont décrits comme suit: Concession minière: le bloc numéro cent soixante-neuf (169), parties du lot numéro trente-sept (37) situées au nord-ouest et nord-est du lac Hélène, partie du lot numéro trente-huit (38) située au nord du lac Hélène, et partie du lot numéro trente-neuf (39) située au nord du lac Hélène, dans le cinquième rang: le lot numéro trente-sept (37) et la partie sud du lot numéro trente-huit (38), dans le sixième rang; Concession minière souterraine: les droits de mine dans partie est de partie nord de la partie du lot numéro trente-sept (37) située au sud du lac Hélène, limitée au sud par une ligne à mi-distance des lignes nord et sud du cinquième rang, dans partie nord de partie du lot numéro trente-huit (38) située entre les lacs Hélène et Adeline (Paonct), limitée au sud par une ligne à mi-distance des lignes nord et sud du cinquième rang; et partie nord de partie du lot numéro trente-neuf (39) située entre les lacs Hélène et Adeline (Paonet), limitée au sud par une ligne à mi-distance des lignes nord et sud du cinquième rang, le tout dans le cinquième rang, canton de Beauchastcl, district électoral de Rouyn-Noran-da.Le tout formant une superficie totale de 251.99 acres et connu comme étant la concession minière N° 370 pour métaux supérieurs, vendue à Win-gate Gold Mines Limited (N.Ç.L.) le 26 novembre 1948.Québec, le 29 avril 1958.Le Sous-ministre des Mines, 47720-19-2-o A.O.DUFRESNE.of the Quebec Mining Act, and in default of the performance of the conditions prescribed by law, will cancel the sale of the mining lands hereunder described, after the publication of this notice in two issues of the Quebec Official Gazette, and once in a French newspaper and once in an English newspaper of the city of Montreal and after the transmission of this notice, by registered mail, to the purchaser, at his known address.The mining lands are described as follows: Mining concession: Parts of lot thirty-seven (37) situated to the North West and to the North East of the lake Helene; part of lot thirty-eight (38) situated to the north of lake Helene, part of lot thirty-nine (39) situated to the north of lake Helene, and block number one hundred and sixty-nine (169) in the fifth (V) range; lot thirty-seven (37) and the south part of lot thirtv-eight (38) in the sixth (VI) range; Underground Mining concession: the mines, minerals and mining rights in the east part of the north part of that part of lot thirty-seven (37) situated to the south of lake Helene, bounded to the south by a line drawn halfway between the north and south lines of range five (V); in the north part of that part of lot thirty-eight (38) situated between lakes Helene and Adeline (Paonet) bounded to the south by a line drawn halfway between the north and south lines of range five (V) and in the north part of that part of lot thirty-nine (39) situated between lakes Helene and Adeline (Paonet), bounded to Jhe south by a line drawn halfway between the north and south lines of range five (V), all in the fifth (V) range, of the township of Beauchastel, electoral district of Rouyn-Noranda.The whole forming a total area of 251.99 acres and known as mining concession No.370, for superior metals sold to Wingate Gold Mines Limited (N.P.L.) on November 26th.1948.Quebec, April 29, 1958.1 A.O.DUFRESNE, 47720-19-2-o Deputy Minister of Mines.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foye (municipalité de cité de Ste-Foy) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné qu'une partie «les lots .293-3 à 293-6 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 avril 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47098-o A VILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg (municipalité de ville de Charlesbourg) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 1062-1209 à 1062-1262 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 avril 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47698-0 AVILA BÊDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of Ste-Foye (municipality of city of Ste-Foy) registration division of Quebec.Notice is hereby given that part of lots 293-3 to 293-6 has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, April 24, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 47698-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Charlesbourg (municipality of town of Charlesbourg) registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 1062-1209 to 1062-1262 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, April 21, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVDLA BÊDARD, 47698-o Deputy Minister. 1738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 Cadastre officiel du quartier St-Antoine (municipalité de la cité de Montréal) division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 1112,1113,1114,1357,1358,1360 à 1372,1107-8, 1109-1 à 1109-3,1112-1 à 1112-8, 1359-1 à 1359-5, 1359-6-2, 1366-1, 1367-1, 1368-1 à 1368-3, 1369-1 et 1373-1 et une partie des lots 1107 à 1110, 1115 à 1121, 1359, 1373 à 1375, 1107-5 à 1107-7, 1109-4 et 1359-6 sont annulés et les lots 1904 à 1907, 1913 et 1914 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 mars 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47698-o AVI LA BÊDARD.Cadastre officiel du quartier St-Antoine (municipalité de la cité de Montréal) division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 1006, 1008 à 1017, 1101 A, 1004-1 à 1004-19, 1107-1 à 1107-4, 1111-4 et une partie des lots 1004, 1005, 1007, 1018, 1019A, 1020, 1101 à 1105, 1107, 1110, 1111, 1107-5 à 1107-7, 1111-1 à 1111-3 et 1111-5 sont annulés et les 1908 à 1912 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Çuébec, le 21 avril 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 47698-o AVILA BÊDARD.Département du Travail Officiai cadastre of St.Antoine ward (municipality of the city of Montreal) registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 1112, 1113, 1114, 1357, 1358, 1360 to 1372, 1107-8, 1109-1 to 1109-3, 1112-1 to 1112-8, 1359-1 to 1359-5, 1359-6-2, 1366-1, 1367-1, 1368-1 to 1368-3, 1369-1, 1373-1, part of lots 1107 to 1110, 1115 to 1121, 1359, 1373 to 1375» 1107-5 to 1107-7, 1109-4, 1359-6 are cancelled and lots 1904 to 1907, 1913 and 1914 are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, March the 21st, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 47698-o Deputy Minister.Official cadastre of St.Antoine ward (municipality of the city of Montreal) registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 1006, 1008 to 1017, 1101 A, 1004-1 to 1004-19,1107-1 to 1107-4, 1111-4 and part of lots 1004, 1005, 1007, 1018, 1019A, 1020, 1101 to 1105, 1107, 1110, 1111, 1107-5 to 1107-7, 1111-1 to 1111-3 and 1111-5 are cancelled and lots 1908 to 1912 are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, April the 21st, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 47698-o Deputy Minister.Department of Labour AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de l'alimentation au détail dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 1658 du 17 mai 1954 et amendements, lui ont ftrésenté une requête à l'effet de soumettre à 'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante audit décret: 1° L'énumération des parties contractantes de première part sera remplacé par la suivante: \"La Section des Produits alimentaires de l'Association des Marchands Détaillants du District de Québec.\" 2° Le paragraphe \"6\" de l'article I sera remplacé par le suivant: \"b) Le terme \"produits alimentaires\" désigne tous produits d'alimentation, effets comestibles ou nom-tels que viande cuite ou crue, charcuterie, poisson, épicerie, légumes, bonbons, fruits, liqueurs, bière, savon, etc.; cette nomenclature n'étant pas limitative.\" 3° Les paragraphes \"o\", \"b\", \"c\", \"rf\", \"s\" et \"g\" de l'article ni seront remplacés par les suivants: \"a) La semaine régulière et normale de travail dans les établissements assujettis au présent décret est de quarante-huit (48) heures réparties comme suit: NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the food products retail trade in the district of Quebec, rendered obligatory by decree No.1658 of May 17th, 1954, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor-in Council the following amendment to the said decree: 1.The enumeration of the contracting parties of the first part will be replaced by the following: \"La Section des Produits alimentaires de l'Association des Marchands Détaillants du District de Québec\".2.Paragraph \"6\" of article I will be replaced by the following: \"6) The term \"food products\" means and includes any food or victual such as cooked or raw meat, pig meat, fish, grocery, vegetables, bonbons, fruits, soft drinks, beer, etc.; this list not bein restrictive.\" 3.Paragraphs \"a\", \"6\", \"c\", \"d\", \"«\" and \"g\" of article III will be replaced by the following: \"a) The regular and standard work week in the establishment governed by the present decree shall consist of forty-eight (48) hours, distributed as follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1739 1.Le lundi: de 1.00 p.m.à 6.00 p.m.; toutefois si, durant, la semaine, il y a un mur chômé et payé, le lundi précédant le travail sera de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; 2.Les mardi, mercredi, jeudi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; 3.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; 4.Le samedi: de 8.00 a.m.à 5.00 p.m.; 5.Le Vendredi-Saint, le travail pourra se faire suivant la condition des heures des offices de la ville et de la banlieue, soit l'après-midi, avec fermeture à 6.00 p.m.ou le soir avec ouverture à 6.00 p.m.et fermeture à 9.00 p.m.Toutefois, le choix devra être approuvé par le Comité paritaire.\" \"b) Pendant la période des fêtes, soit trois (3) jours ouvrables avant la veille de Noël et deux (2) jours ouvrables avant la veille du Premier de l'An, y compris la veille des autres jours chômés, les heures de travail peuvent être prolongées jusqu'à 9.00 p.m., le salarié régulier n'ayant droit à aucun salaire pour le travail exécuté durant telles heures additionnelles.Cependant, la veille de Noël et du Premier de l'An, tout travail doit cesser à 6.00 p.m.\" \"c) En dehors des heures mentionnées ci-haut, et durant les jours de fêtes chômées, un salarié ne peut travailler à la vente des produits alimentaires au comptoir, par téléphone ou par livraison, et un employeur ou un employeur professionnel ne peut travailler ni faire travailler un salarié à la vente des produits alimentaires au comptoir, par téléphone ou par livraison.\" \"d) Jours de fêtes chômés: Tout employé régulier doit être rémunéré au taux régulier ou au taux de salaire qui lui est actuellement payé, si ce dernier taux est supérieur à celui du décret, pour les jours de fêtes chômés suivants: le Premier de l'An, le 2 janvier, l'Epiphanie, le jour de l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération, la fête du Travail, la Toussaint, l'Immaculée Conception, le jour de Noël et le lendemain de Noël et tous les autres jours autres que les jours chômés non mentionnés ci-haut, où l'employeur tient son établissement fermé, en autant que l'employé aura travaillé la veille et le lendemain du jour chômé.Lorsque le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération et le 2 janvier tombent un dimanche, le lundi suivant immédiatement est chômé et payé; si les autres jours de fêtes chômés énumérés à l'alinéa' précédent tombent un dimanche ils ne sont pas payés.Nonobstant les deux paragraphes précédents, si les jours de fêtes chômés suivants: l'Epiphanie, le jour de l'Ascension, la Toussaint, l'Imma-culée-Conception et le congé du lendemain de Noël tombent un vendredi ou un samedi, le jour chômé sera reporté au lundi suivant et l'employeur ne devra ouvrir ses portes qu'à 9.00 a.m.ces jours-là.\" \"e) Tout travail exécuté par un salarié en Elus de 48 heures par semaine ou en dehors des eures de travail déterminées au paragraphe \"a\" ci-haut est considéré comme travail supplémentaire et doit être rémunéré conformément au paragraphe \"c\" de l'article V.\" \"g) Tout salarié a droit au moins à une heure et trente minutes pour prendre son repas du midi à l'heure fixée par l'employeur et à un temps égal pour le repas du soir, les jours où le travail se prolonge jusqu'à 9.00 p.m., le tout pendant les heures prévues au paragraphe \"à\" du présent article.4° Aux paragraphes \"h\" et \";\" de l'article V, les mots \"cinquante-deux heures et demie (52^)\" seront remplacés par les mots \"quarante-huit (48) heures\".1.Monday: from 1.00 p.m.to 6.00 p.m.; however, should there occur in the week a holiday with pay, working hours on the preceding Monday 'shall be from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.; 2.Tuesday, Wednesday, Thursday: from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.; 3.Friday: from 8.00 a.m.to 9.00 p.m.; 4.Saturday: from 8.00 a.m.to 5.00 p.m.; 5.On Good Friday, hours may be worked in accordance with religious services hours, either in the afternoon with closing time at 6.00 p.m., or in the evening with starting time at 6.00 p.m.and closing time at 9.00 p.m.However, the decision in such cases must be approved by the Parity Committee.\" \"b) For the holidays period, i.e.three (3) working days before Christmas Eve and two (2) working days before New Year's Eve, including tht eve of the other holidays, the working hours may be extended until 9.00 p.m., and regular employees shall hot be entitled to any remuneration for work performed during such overtime hours.However, on Christmas and New Years' eves, all work shall cease at 6.00 p.m.\" \"c) Outside the hours above mentioned and on holidays, an employee shall not work at the sale of food products at the counter, by telephone or delivery and employers or professorial employers shall not work or cause an employee to work at the sale of food products at the counter, by**' telephone or delivery.\" \"d) Observed holidays: Every regular employee shall receive the regular rate of pay or the rate actually paid to him, if the latter is higher than the one fixed by the decree, for the following observed holidays: New Year's Day, January 2, Epiphany Day, Ascension Day, St.Jean Baptiste Day, Confederation Day, Labour Day, All Saints' Day, Immaculate Conception Day, Christmas Day and the day after Christmas and all days other than the observed holidays which are not mentioned above, during which the establishment of the employer is closed, provided the employee has worked the day before and the day after the day off.When St.Jean Baptiste Day, Confederation Day and January 2 fall on Sunday, the following Monday is observed as a holiday with pay.When the other holidays enumerated in the foregoing paragraph fall on Sunday, they are not paid.Notwithstanding the foregoing two paragraphs, when Epiphany Day, Ascension Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day and the day after Christmas fall on a Friday or a Saturday, the holiday or day off is postponed to the following Monday and employers shall not open before 9.00 a.m.on such days.\" \"e) All time worked by an employee in excess of forty-eight (48) hours in one week or in excess of the working hours determined in paragraph \"a\" hereof shall be considered as overtime work and remunerated in pursuance of paragraph \"c\" of article V.\"g) Every employee shall be entitled to at least one hour and thirty minutes for the noon meal, the time of such period to be fixed by the employer, and to a similar period for the evening meal when work ceases at 9.00 p.m., within the hours mentioned in paragraph \"a\" hereof.\" 4.In pragraphs \"h\" and \"j\" of article V, the words \"fifty-two hours and a half (52^)\" will be replaced by the words \"forty-eight (48) hours\". 1740 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1958, Tome 90, N° 19 5° Aux sous-paragraphes 1:°, 2° et 3° du paragraphe \"A\" de l'article V, les mots \"cinquante-deux heures et demie (52^)\" seront remplacés par les mots \"quarante-huit (48) heures\".6° Aux paragraphes \"o\" et \"d\" de l'article VI, les mots \"30 septembre\" seront remplacés par les mots \"30 octobre\".7° L'article VIII sera remplacé par le suivant: \"VHL.Durée du décret' Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1960.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) jours ni de moins de trente (30) jours avant le 28 février de l'année 1960 ou de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle' de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 10 mai 1958.47715-o AVIS L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: The Builders' Exchange, dont le siège social est à Montréal, agissant pour et au nom des Maisons suivantes: A.& S.Architectural Iron Works; Canadian Welding Works Limited; A.Faustin, Co.Limited; Locweld & Forge Products Limited; Montreal Forged Products Limited; Montreal Iron Works Limited; Montreal Metalworked Products Limited; Ornamental Metal & Machine Works Limited; Tremblay & Boucley Enr'g., toutes de la cité de Montréal, Et, d'autre part: Le local numéro 2366 de \"The United Steel Workers of America\" de la cité de Montréal, pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions ci-après décrites: I.Juridiction: a) Juridiction industrielle: Le présent décret régit toute fabrication, transformation, opération et montage: i.de metal ouvré pour fins industrielles et de construction, à l'exception des charpentes métalliques de bâtiments; ii.de constructions architecturales au moyen de métaux d'ornementation pour fins architecturales ou utilitaires, comprenant, entre autres, les articles suivants: 1.Portes, chassis et seuils; 5.In sub-paragraphs 1, 2 and 3 of paragraph \"h\" of article V, the words \"fifty-two hours and a half (52^)\" will be replaced by the words \"forty-eight (48) hours\".6.In paragraphs \"a\" and \"d\" of article VI, the words \"September 30th\" will be replaced by the words \"October 30th\".7.Article VLTI will be replaced by the follow-wing: \"VHL Duration of the decree: The present decree rerqains in force until February 28, 1960.It then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notified the other party, in writing, to the contrary within the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day prior to February 28 of the year 1960 or of any subsequent year.Such a notice must also be filed with the Minister of Labour.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the -objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Département of Labour, Quebec, May 10.1958.47715-o NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties hereafter mentioned have submitted a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: Between The Builders' Exchange, with the head office in Montreal, acting for and in the name of the following firms; A.& S.Architectural Iron Works; Canadian Welding Works Limited; A.Faustin, Co.Limited; Locweld & Forge Products Limited; Montreal Forged Products Limited; Montreal Iron Works Limited; Montreal Metal-worked Products Limited; Ornamental Metal & Machine Works Limited; Tremblay & Boucley Enr'g, all of the city of Montreal, And, on the other part: Local No.2366 of the United Steel Workers of America of the city of Montreal, for the employers and the employees of the industry and trades concerned, according to the following conditions : I.Jurisdiction: a) Industrial jurisdiction: This decree governs the manufacture, processing, fabrication and erection of: i.industrial and building metalwork with the exception of the structural steel framing for buildings; li.architectural work in all metals used for ornamentation, architecturally or for utilitarian purposes including, but not necessarily restricted to the following specific items in metal: 1.Doors, frames and sills; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1958, Vol.90, No.19 1741 2.Escaliers, échelles de sauvetage ou autres et coursives; 3.Clôtures, barrières et balcons; 4.Garde-fous, angles de bordure, charpentes et panneaux de trous et de fosses; 5.Grilles, garde-fenêtres, cages et divisions.6) Juridiction professionnelle: Le présente dé- 2.Stairs, fire escapes, ladders and cat walks; 3.Railing, gates and balconies; 4.Protection guards, curb angles, hole and pit frames and covers; 5.Grilles, window guards) cages and partitions.b) Professional jurisdiction: This decree gov- cret régit les salariés travaillant dans les usines erns all employees in the shops comprised in the incluses dnas la juridiction industrielle détermi- industrial jurisdiction determined in subsection née au paragraphe \"a\" du présent article.c) Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du présent décret comprend trois (3) zones dont la description est la suivante: Zone I: L'Ile de Montréal, l'Ile Bizard, les a\" of the present section, c) Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the present decree comprises three (3) zones described hereinbelow: Zone I: The Island of Montreal, l'Ile Bizard, districts électoraux de Laval, Deux-Montagnes, the electoral districts of Laval, Deux Montagnes, Argenteuil, Soulanges, Vaudreuil, Beauharnois, Argenteuil, Soulanges, Vaudreuil, Beauharnois, Châteauguay, Laprairie, Chambly, Saint-Jean Châteauguay, Laprairie, Chambly, St.John's etB>erville; and R)erville; Zone II: Les districts électoraux de Terra- Zone II: The electoral districts of Terrebonne, bonne, Trois-Rivières, Saint-Maurice, Cham- Trois-Rivières, St.Maurice, Champlain, Lavio- plain, Laviolette, Drummond, Arthabaska, Saint- lette, Drummond, Arthabaska, St.Hyacinthe Hyacinthe et Sherbrooke; and Sherbrooke; Zone III: Les districts électoraux de Maski- Zone III: The electoral districts of Maskinon- nongé, Berthier, Joliette, l'Assomption, Montcalm, Portneuf, Nicolet, Yamaska et Rouville; Nonobstant les dispositions du paragraphe \"a\" de la présente section, ce décret ne régit pas le gé, Berthier, Joliette, l'Assomption, Montcalm, Portneuf, Nicolet, Yamaska and Rouville; Notwithstanding the provisions of subsection 'V of the present section, the decree does not travail de montage exécuté dans les zones II et govern erection work performed in Zones Hand HI.III.II.Taux de salaires: Les taux minima de II.Rates of wages: The minimum hourly rates salaires pour chacune des classifications sont of wages for each one of the following classifica- les suivants: tions shall be: ~Zane I Taux Zone I horaires Minimum minima Classifications Hourly rates .$1.70 Mechanic.$1.70 .1.50 Fitter.1.50 .150 Blacksmith.1.50 Aide (boutique ou chantier).1.30 Helper (shop or field).1.30 Monteur.1.70 Erector.1.70 Classifications: Mécanicien.Ajusteur., Forgeron.Zone II Zone II Mécanicien.Ajusteur.Forgeron.Aide.Zone III Mécanicien.Ajusteur.Forgeron.Aide, après 3 mois.Aide en probation, 1er trimestre.1.55 Mechanic.135 Fitter.135 Blacksmith.120 Helper.Zone III 1.40 Mechanic.1.30 Fitter.1.30 Blacksmith.1 -15 Helper, after 3 months.1 00 Helper on probation, 1st 3 months .1.55 1.35 1.35 1.20 1.40 1.30 1.30 1.15 1.00 Clause additionnelle: Les mécaniciens et les ajusteurs peuvent exécuter du travail de soudeur ou de forgeron sans avoir à se procurer un certificat de qualification dans ces métiers.Lorsqu'ils sont affectés à tel travail, ils reçoivent le taux du mécanicien ou de l'ajusteur, selon le cas.III.Durée du travail: a) La durée hebdomadaire du travail est de quarante-quatre (44) heures distribuées comme suit: Neuf (9) heures par jour le lundi au jeudi inclusivement et huit (8) heures le vendredi entre 7.30 a.m.et 6.00 p.m.chaque jour; ou Huit (8) heures par jour le lundi au vendredi inclusivement entre 7.30 a.m.et 6.00 p.m.et quatre (4) heures le samedi entre 7.30 a.m.et midi.b) La durée hebdomadaire du travail des équipes de nuit est de quarante-quatre (44) heures distribuées comme suit: Neuf (9) heures par jour le lundi au jeudi inclusivement et huit (8) heures le vendredi Provisio: Mechanics and fitters may execute such welding or blacksmithing work as may be necessary without obligation to possess a card of competency in such trade and, when so employed, they shall be remunerated as mechanics or fitters, as the case may be.III.Duration of labour: a) The weekly duration of labour shall be forty-four (44) hours distributed as follows: Nine (9) hours per day Monday to Thursday inclusive and eight (8) hours on Friday between 7.30 a.m.and 6.30 p.m.on each day; or Eight (8) hours per day Monday to Friday inclusive between 7.30 a.m.and 6.00 p.m.and four (4) hours between 7.30 a.m.and 12.00 noon on Saturday.6) The weekly duration of labour on night shifts shall be forty-four (44) hours distributed as follows: Nine (9) hours per day Monday to Thursday inclusive and eight (8) hours on Friday between 1742 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 entre 6.00 p.m.et 6.00 a.m.de la journée qui suit; ou Huit (8) heures par jour le lundi au vendredi inclusivement entre 6.00 p.m.et 6.00 a.m.de la journée qui suit et quatre (4) heures entre 6.00 p.m.et minuit le samedi.IV.Travail supplémentaire: a) Le travail exécuté en plus des heures régulières ou en dehors des limites spécifiées dans la Section LTI est considéré comme travail supplémentaire.b) Le travail supplémentaire doit être payé au taux de temps et demi.c) Le travail exécuté le Premier de l'An, le Vendredi Saint, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération (le 1er juillet), le jour de la Fête du Travail, le jour d'Actions-de-GrAces, le jour de Noël et les dimanches doit être payé au taux de temps double.V.Équipe de nuit: Les salariés faisant partie de l'équipe de nuit doivent recevoir une prime de $0.05 l'heure en plus des taux réguliers.< Tout travail supplémentaire de l'équipe de nuit doit être payé sur la base de temps et demi du taux de l'équipe.VI.Jours de fêtes payés: Le Premier de l'An, le Vendredi Saint, le jour de la Confédération, le jour de la Fête du Travail et le jour de Noël sont des jours de fêtes payés au taux simple, pourvu qu'ils tombent un jour régulier de travail et pourvu aussi que le salarié ait été au travail le jour ouvrable qui précède et celui qui suit tels jours de fête.VU.Vacances payées: a) Dans le but d'établir des vacances payées, la période de prestations doit s'étendre sur douze (12) mois à partir du 1er mai d'une année jusqu'au 30 avril de l'année suivante; b) Un salarié qui a travaillé pour le même employeur pendant moins longtemps qu'une période complète de prestations doit avoir une demi-journée de vacances payée pour chaque mois de .travail; e) Un salarié qui a travaillé pour le même employeur pendant au moins une période complète de prestations mais pendant moins que cinq a droit à une semaine de vacances payée; d) Un salarié qui a travaillé pour le même employeur pendant plus de cinq périodes de prestations doit avoir deux semaines de vacances payées; e) Les vacances sont données dans les périodes 3ui conviennent à l'employeur mais les salariés oivent en être avisés d'avance.VIH.Apprentissage: a) Les apprentis-mécaniciens dans l'usine doivent recevoir le pourcentage suivant basé sur les taux de salaires des mécaniciens: 1ère année, 1er semestre.25% 1ère année, 2ième semestre.30% 2ième année.45% 3ième année.60% 4ième année.75% b) Les apprentis-mécaniciens dans l'usine ne doivent pas commencer leur apprentissage avant d'avoir 16 ans ou après l'âge de 23 ans.Quatre (4) années constituent la période d'apprentissage, c'est-à-dire que chaque apprenti doit avoir travaillé pendant deux cent huit(208) semaines.Il est permis d'avoir un (1) apprenti pour chaque groupe de sept (7) salariés travaillant dans un atelier.Si un employeur à moins de sept (7) salariés, il lui est quand même permis d'avoir 6.00 p.m.and 6.00 a.m.the following morning of each day; or Eight (8) hours per day Monday to Friday inclusive between 6.00 p.m.and 6.00 a.m.the following morning of each day and four (4) hours between 6.00 p.m.and 12.00 midnight Saturday.IV.Overtime work: a) Work performed in excess of the regular hours or outside the limits determined in Section HI shall be considered as overtime work.t b) Overtime work shall be paid at the rate of time and one-half.c) Work performed on New Year's Day, Good Friday, St.Jean Baptiste Day, Confederation Day (July 1) Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day and Sundays shall be paid at the rate of double time.V.Night shifts: Employees working on night shifts shall be paid a premium of 5c per hour in excess of regular rates.AU overtime on night shifts shall be paid on the basis of one and one-half times the shift rate.VI.Paid holidays: New Year's Day, Good Friday, Confederation Day, Labour Day and Christmas Day shall be holidays with pay at regular or single rate» of pay, provided that such day falls on a regular work day, and provided further that the employee shall have been at his employment on the work day preceding and the work day following the Statutory Holiday.VU.Vacations with pay: a) For the purpose of establishing vacations with pay, the credit Seriod shall extend for twelve (12) months from lay 1st in one year to April 30th in the next year.b) An employee who has worked for the same employer for less than one full credit period shall be entitled to one-half day's vacation with pay for each month worked.e) An employee who has worked for the same employer for one credit period but less than five shall be entitled to one week's vacation with pay.d) An employee who has worked for the same employer for more than five credit periods shall be entitled to two weeks' vacation with pay.e) The vacation period will be arranged at the convenience of the employer but he will give the employees notice in advance of the time.VIH.Apprenticeship: a) Apprentice-mechanics in the shop shall receive the following percentage computed on the mechanic's rates of wages: 1st year, 1st six months.25% 1st year, 2nd six months.30% 2nd year.45% 3rd year.60% 4th year.75% b) Apprentice-mechanics in the shop shall not begin their apprenticeship before-16 years of age or after 23.Four (4) years shall constitute the complete apprenticeship period meaning that each apprentice must work during two hundred and eight (208) weeks.One (1) apprentice is allowed to each group of seven (7) employees in a shop.II an employer has less than seven (7) employees, he still may have one (1) apprentice.Sections IV and V concerning overtime work and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1743 un (1) apprenti.Les Sections IV et V qui traitent du temps supplémentaire et des équipes de nuit s'appliquent aux apprentis.e) Au terme de sa période d'apprentissage, le Comité Paritaire détermine la catégorie à laquelle le salarié doit appartenir et un avis spécial est émis à cet effet.d) Les apprentis qui ont fréquenté une école régie par la Loi de l'Enseignement spécialisé doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études et aux.résultats de leurs night shifts shall apply to apprentices; examens.IX.Clauses spéciales: a) Le salarié requis de se présenter au travail a droit à une rémunération minimum équivalente à trois (3) heures aux taux alors en vigueur et ce, cahque fois qu'il est demandé lorsqu'il n'y a pas de travail à exécuter; 6) L'heure normale ou avancée s'applique selon le cas suivant l'heure alors en vigueur à l'endroit où le travail est exécuté.X.Classifications temporaires: Les salariés requis de travailler temporairement dans une classification dont le taux de salaire est inférieur à celui de leur classe habituelle doivent recevoir le taux de leur classe.XI.Travail à la pièce: Les contrats intervenus entre un employeur et un ou plusieurs salariés sur une base de travail à la pièce ou à contrat sont de nul effet et strictement défendus.XII.Paiement du salaire: Le salaire du salarié doit bien être remis dans une enveloppe scellée devant contenir les détails suivants: 1.les nom et prénom du salarié; 2.la date de la période de paie; 3.les -déductions faites; 4.le montant contenu dans l'enveloppe.Si les salaires sont payés par chèque, les mêmes détails doivent être mentionnés sur le,chèque ou sur un mémo approprié.XIII.Durée du décret: Le présent décret est valable à compter du jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1959.Il se renouvelle automatiquement par la suite d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai de pas plus de soixante (60) jours (mais pas moins de trente (30) jours) avant la date de son expiration originale ou de son renouvellement selon le cas.Un tel avis doit être également être adressé au Ministre du Travail.XIV.Observance: L'observance du décret sera surveillée et assurée par le Comité Conjoint des Matériaux de Construction de Montréal.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 10 mai 1958.47715-o c) On completion of his apprenticeship period, the Joint Committee shall determine in which category the employee is to be classified and a special notice shall be issued accordingly.d) Apprentices who have attended a school under the specialized Schools Act shall receive a credit in proportion to the duration of their studies and the result of their examinations.IX.Special provisions: a) An employee required to report to work shall be paid for a minimum of three (3) hours at prevailing rates, each time he is called when work is not available; b) The hours shall be Standard or Daylight Saving Time depending on which time is in force in the locality where the work is performed.X.Temporary classifications: Employees required to work temporarily in a classification lower than their regular oria^shall be paid at the rate of their own classification.XI.Piece-work: No employer shall make any arrangement whatsoever with any employee with, piece-work as the basis for payment of labour performed.XH.Payment of wages: Employee's wages shall be paid in a sealed envelope on which shall be indicated the following particulars: 1.the name and surname of the employee; * 2.the date of the pay period.3.the deductions made; 4.the amount contained in the envelope.If wages are paid by cheque the same particulars shall be given on the cheque or by other suitable memo.XIII.Duration of the decree: The present decree shall come into effect on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and shall remain effective until March 31, 1959.It shall be renewed automatically thereafter from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary within sitxy (60) days, (but not less than thirty (30) days) of the expiry of the regular term or renewal, as the case may be.Such noti-'ce shall also be sent to the Minister of Labour.XIV.Administration: This decree shall be administered by the Building Materials Joint Committee of Montreal.The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, .Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, May 10, 1958.47715-o 1744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 mai 1968, Tome 90, N° 19 - Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DE SAINT-FRANÇOIS \u2014 BAR OF ST.FRANCIS Candidats aux examens d'admission A la pratique du droit Candidates to the examinations for admission to the practice or law Noma Names\tPrénoms Surnames\tAge\tRésidence Residence\tCollèges Colleges ¦' \tJean.\t25 30 26 27\tSherbr opks.\tUniversité de Sherbrooke.Université de Montréal.Université de Montréal.Université de Sherbrooke.Geoffroy.\tJ.-Gilles.\t\t\t \tPaul.\t\tSherbrooke.v.Beebe.L.\t \t\t\t\t Sherbrooke, ce 30 avril 1958 \u2014 Sherbrooke, April 30th, 1958.Le Secrétaire du Barreau de Saint-Francois, CHARLES LEBLANC, Secretary of the Bar of St.Francis.BARREAU DE TROIS-RIVIÈRES \u2014 BAR OF TROIS-RIVIÈRES Candidats pour l'admission à l'examen Candidates for the admission to the examination \tNoms\t\tPrénoms\t-\tRésidence \t\u2014\t\t\u2014 \u2022\tAge\t\u2014 \tNames\t\tSurnames\t\tResidence \t\t\t\t25 27\tShawinigan.Shawinigan.Trudel.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Trois-Rivières, 6 mai 1958 \u2014 Trois-Rivières, May 6, 1958.Le Secrétaire du Barreau de Trois-Rivières, J.-LOUIS SANSCHAGIUN, Secretary of the Bar of Trois-Rivières.Lettres patentes Letters Patents Collège de Matane College de Matane * Avis est donné qu'en vertu des dispositions Notice is hereby given that under the provide l'article 20 de la Loi des évoques catholiques sions of section 20 of the Roman Catholic romains, 14 George VI, chapitre 76, il a été Bishops' Act, 14, George VI, chapter 76, letters accordé par le Lieutenant-gouverneur de la patent have been granted by the Lieutenant-province de Québec des lettres patentes, en date Governor of the Province of Quebec on the first du premier mai 1958, constituant en corporation of May, 1958, incorporating the \"Collège de le \"Collège de Matane\".t Matane\".Le siège social de la corporation ci-haut men- The head office of the above mentioned cor- tionnée est situé en la ville de Matane.poration is situated in the town of Matane.Donné au bureau du Secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary le sept mai 1958.on May seventh, 1958.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHESI, 47738-o JEAN BRUCHESI.47738 .Under Secretary of the Province.Ministère des.Finances Assurances Avis de changement de nom Avis est donné par les présentes (a) que \"Fire Association of Philadelphia\", constituée en cor- Çoration conformément ^ aux lois de l'État de ennsylvanie, États-Unis d'Amérique, et enregistrée dans la province sous le numéro 228, a changé son nom en celui de \"Reliance Insurance Company\", et (b) que la compagnie n'est autorisée à employer ce nom dans la province qu'à la condition de le faire suivre des mots aof Philadelphia\".Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 24 avril 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 47667-18-2-o Surintendant des assurances.Department of Finance\" Insurance Notice of change of name , Notice is hereby given (a) that \"Fire Association of Philadelphia\", incorporated under the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, United States of America, and registered in this Province under number 228, has changed its name to \"Reliance Insurance Company\", and (6) that the company is authorized to use this name in the Province on the condition that it is followed by the words \"of Philadelphia\".Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 24th of April 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 47667-18-2-0 Superintendent of Insurance. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1745 Avis de changement de nom \u2014 « Avis est par les présentes donné que \"Alliance Nationale\" compagnie constituée en corporation par le chapitre 60 des Statuts du Canada de 1917 et enregistrée dans la province sous le numéro 477, a changé son nom en celui de \"Alliance Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie \u2014 Alliance Mutual Life Insurance Company\" le 1er janvier 1958.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 3 mai 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 47739-o Surintendant des assurances.Notice of change of name Notice is hereby given that \"Alliance Nationale\", company incorporated by chapter 69 of the Statutes of Canada of 1917 and registered in the Province under number 477, has changed its name to \"Alliance Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie \u2014 Alliance Mutual Life Insurance Company\" on the 1st of January 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 3rd of May 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 47739-0.Superintendent of Insurance.Nomination Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et1 par commission, de faire la nomination suivante: Québec, le 3 avril 1958.M.Camille-L.de Martigny, avocat, membre du Barreau de la province, conseil en loi de la Reine, domicilié dans la cité de St-Jérôme: nommé, en vertu de l'article 267 de la Loi des tribunaux judiciaires, à compter du premier mai 1958, juge de district, avec résidence dans la cité de St-Jérôme, et avec juridiction dans toute la province, mais particulièrement et sans restriction dans les districts judiciaires de Terre-bonne et Labelle, et pour agir, dans la province, selon l'article 21 de la loi 1-2 Elizabeth U, chapitre 29, comme magistrat de district en ce qui concerne les juridictions attribuées par les lois du Parlement du Canada aux magistrats de district, que ces juridictions leur soient .attribuées sous le titre de \"magistrat\" ou sous celui de \"magistrat de district\", ledit M.Camille-L.de Martigny, vu sa présente nomination par le Lieutenant-gouverneur en conseil comme juge de district, étant en outre autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe b) de l'article 466 du Code criminel, à compter du premier mai 1958, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI de ce Code criminel.47697-o Appointment His Honour, the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, to make the following appointment: Quebec, April 3, 1958.Mr.Camille-L.de Martigny, advocate, member of the Bar of the Province of Quebec, Queen's Counsel, domiciled in the city of St-Jérôme: appointed, under section 267 of the Courts of Justice, from and after the first day of May, 1958, District Judge, with' residence in the city of St-Jérôme, and with jurisdiction in the whole of the Province, but especially and without restriction within the judicial limits of Terrebonne and Labelle, and to act, in the Province, according to section 21 of the Act 1-2 Elizabeth II, chapter 29, as District Magistrate in that which concerns .the jurisdictions attributed by the Acts of the Parlement of Canada to District Magistrates, that these jurisdictions be attributed to them under the title of \"magistrate\" or under that of \"District Magistrate\", the said Mr.Camille-L.de Martigny, in view of his present appointment by the Lieutenant-Governor in Council as District Judge, being, moreover, authorized to excercice, under the authority of paragraph 6) of section 466 of the Criminal Code, to count as from May 1st, 1958, the jurisdiction of a Magistrate under Part XVI of this Criminal Code.47697 Office des Marches Agricoles du Québec AVIS Un projet de plan conjoint présenté par \"L'Association des producteurs de tabac jaune du Québec Inc.\", de Joliette, P.Q.comprenant les produits agricoles suivants: \"Tabac jaune produit dans les comtés de l'Assomption, Berthier, Joliette, Verchères, Richelieu, St-Maurice et Champlain, et vendu aux acheteurs commerciaux faisant affaires dans la Province de Québec\" a été reçu et approuvé pour enquête et adjudication finale au mérite.Montréal, le 6 mai 1958.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, 47735-0 LÉONARD ROY.Quebec Agricultural Marketing Board NOTICE A petition for a joint marketing plan presented by \"L'Association des producteurs de tabac jaune du Québec Inc.\", Joliette, P.Q.for the following agricultural product: \"Flue \u2014 cured tobacco produced in Assomption, Berthier, Joliette, Verchères, Richelieu, St-Maurice and Champlain countries and sold to commercial buyers doing business in the Province of Quebec\" has been received and approved for investigation and final adjudication on its merits.Montreal, May 6th, 1958.(Judge) GEORGES-H.H EON, Chairman.LÉONARD ROY, 47735-o Secretary. 1746 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 AVIS Un projet de plan conjoint présenté par \"Le Syndicat Spécialisé des producteurs de bois de Rimouski (U.C.C.)\" comprenant les produits agricoles suivants: \"Bois de pulpe provenant des boisés de ferme de leurs propriétaires, situés dans les paroisses suivantes de la région de Rimouski-Matapédia\" : Albertville, Cté Matapédia St-Alexandre-des-Lacs, Cté Matapédia Amqui, Cté Matapédia Causapscal, Cté Matapédia St-Cléophas, Cté Matapédia St-Damasc, Cté Matapédia Ste-Florence, Cté Matapédia Ste-Irène, Cté Matapédia Ste-Jean no d'Arc, Cté Matapédia Lac-au-Saumon, Cté Matapédia La Rédemption, Cté Matapédia St-Léon-le-Grand, Cté Matapédia St-Molse, Cté Matapédia Ste-Marguerite Marie, Cté Matapédia St-Noël, Cté Matapédia Padoue, Cté Matapédia Val-Brillant, Cté Matapédia Ste-Paula, Cté Matapédia Sayabec, Cté Matapédia St-Tharcisius, Cté Matapédia St-Vianney, Cté Matapédia Routhierville, Cté Bonaventure St-Alexis Matapédia, Cté Bonaventure St-André Restigouche, Cté Bonaventure St-Fidèle de Restigouche, Cté Bonaventure St-François-d'Assise, Cté Bonaventure L'Ascension, Cté Bonaventure Matapédia, Cté Bonaventure Ste-Angèle, Cté Matane Ste-Flavie, Cté Matane St-Joseph de Lepage, Cté Matane Mont-Joli, Cté Matane St-Octave de Métis, Cté Matane Price, Cté Matane St-Charles-Garnier, Cté Rimouski St-Donat, Cté Rimouski St-Gabriel, Cté Rimouski Les Hauteurs, Cté Rimouski Ste-Luce, Luceville, Cté Rimouski vendu aux industriels de la pulpe et du papier ou à tous autres acheteurs commerciaux faisant affaires dans la province de Québec\", a été reçu et approuvé pour enquête et adjudication finale au mérite.Montréal, le 24 avril 1958.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, 47735-0 LÉONARD ROY.NOTICE A petition for a joint marketing plan presented by \"Le Syndicat Spécialisé des producteurs de bois de Rimouski (U.C.C.)\" for the following agricultural products: \"Pulpwood produced on the farm wood lots of their owners situated in the following parishes fcf the Rimouski Matapédia Region\": Albertville, Cty Matapédia St-Alexandre-des-Lacs, Cty Matapédia Amqui, Cty Matapédia Causapscal, Cty Matapédia St-Cléophas, Cty Matapédia St-Damase, Cty Matapédia Ste-Florence, Cty Matapédia Ste-Irène, Cty Matapédia Ste-Jeanne d'Arc, Cty Matapédia Lac-au-Saumon, Cty Matapédia La Rédemption, Cty Matapédia St-Léon-le-Grand, Cty Matapédia St-Molse, Cty Matapédia Ste-Marguerite Marie, Cty Matapédia St-Noël, Cty Matapédia Padoue, Cty Matapédia Val Brillant, Cty Matapédia Ste-Paula, Cty Matapédia Sayabec, Cty Matapédia St-Tharcisius, Cty Matapédia St-Vianney, Cty Matapédia Routhierville, Cty Bonaventure St-Alexis Matapédia, Cty Bonaventure St-André Restigouche, Cty Bonaventure St-Fidèle de Restigouche, Cty Bonaventure St -Francois d'Assise, Cty Bonaventure L'Ascension, Cty Bonaventure Matapédia, Cty Bonaventure Ste-Angèle, Cty Matane Ste-Flavie, Cty Matane St-Joseph de Lepage, Cty Matane Mont-Joli, Cty Matane St-Octave de Metis, Cty Matane Price, Cty Matane St-C bar les-Gamier, Cty Rimouski St-Donat, Cty Rimouski St-Gabriel, Cty Rimouski Les Hauteurs, Cty Rimouski Ste-Luce, Luceville, Cty Rimouski sold to the pulp and paper industry or any other commercial buyers doing business in the Province of Quebec\", has been received and approved for investigation and final adjudication on its merits.Montreal, April 24th, 1958.(Judge) GEORGES-H.HÉON, Chairman.LÉONARD ROY, 47735-0 Secretary.Proclamations Proclamations Canada, Province de Québec.[L.S.] O.GAGNON Canada, Province of Quebec.[L.S.] O.GAGNON ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses God of the United Kingdon, Canada and Her autres royaumes et territoires, Chef du Com- other Realms and Territories, Queen, Head of monwealth, Défenseur de la foi.Commonwealth, Defender of the Faith.A tous ceux qui ces présentes lettres verront To all to whom these present letters shall ou qu'icelles pourront concerner, - come or whom the same may concern, Salut.Greeting. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1747 PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( ATTENDU que les général, ) Cours de magistrat C.E.Cantin.\\ ci-dessous mentionnées (sont actuellement inactives et l'ont été depuis une période assez prolongée; Attendu quet> sous l'autorité de l'article 318 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1941, chapitre 15), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'abolir, par proclamation, toute Cour de magistrat qu'il juge à propos et que, à dater du jour fixé à cet effet dans la proclamation, la cour cesse d'être tenue; (If Attendu qu[il y a lieu de décréter l'abolition, par proclamation, des cours ci-dessous mentionnées, vu qu'elles sont inactives.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 30 avril 1958, portant le numéro 410, Nous décrétons et ordonnons l'abolition, à compter du 15 mai 1958, des Cours de magistrat suivantes, à savoir: La Cour de magistrat du comté de Mégantic, à Inverness; La Cour de magistrat du comté de Missisquoi, à Bedford; La Cour de magistrat du comté de Brome, à Knowlton; La Cour de magistrat du comté de Gaspé, à Rivière-au-Renard; La Cour de magistrat du comté de L'Assomption, à L'Assomption; La Cour de magistrat du comté de L'Assomption, à Laurentides; La Cour de magistrat du comté de Labelle, à Labelle; La Cour de magistrat du comté de Labelle, à Nominingue; La Cour de magistrat du comté de Labelle, à L'Annonciation; La Cour de magistrat du comté de Bellechasse, à St-Raphaël; La Cour de magistrat du comté de LTslet, à St-Jean-Port-Joli ; La Cour de magistrat pour la ville de Rigaud, à Rigaud; La Cour de magistrat du comté de Pontiac, à Chapeau; La Cour de magistrat du comté de Pontiac, à Quyon; La Cour de magistrat du comté de Pontiac, à Port-Coulonge; La Cour de magistrat du comté de Pontiac, à Shawville; La Cour de magistrat du comté de Yamaska, à St-François-du-Lac; La Cour de magistrat du comté du Lac St-Jean, à Hébertville-Station; La Cour de magistrat du comté de Charlevoix, à Baie St-Paul; La Cour de magistrat du comté de Stanstead, à Stanstead-Plain; La Cour de magistrat du comté de Compton, à Cook s h ire; La Cour de magistrat du district électoral de Deux-Montagnes, à Ste-Scholastique; La Cour de magistrat du district électoral de Deux-Montagnes, à St-Eustache; La Cour de magistrat du comté de Terrebonne, à Terrebonne.Nous autorisons la transmission des dossiers, registres, documents et archives de chacune de ces Cours de magistrat ainsi abolies au greffe PROCLAMATION C.E.Cantin, ( \"VA/HEREAS the Magis-Deputy Attorney) VV trate's Courts men-General.\\ tioned hereinunder are pre-\\ sently inactive and have been so for a rather prolonged period of time; Whereas, under the authority of section 318 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes 1941, chapter 15), the'Lieutenant-Governor in Council may, by proclamation, abolish any Magistrate's Court he may deem proper, and from and after the date fixed by such proclamation, the court shall no longer be held; » Whereas it is deemed expedient to abolish, by proclamation, the courts mentioned hereinunder, owing to their inactivity.Therefore with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated April 30, 1958, bearing number 410, We decree and ordain the abolishment, as from May 15, 1958, the following Magistrate's Courts, to wit: The Magistrate's Court of the County of Megantic, at Inverness; The Magistrate's Court of the County of Missisquoi, at Bedford; The Magistrate's Court of the County of Brome, at Knowlton; The Magistrate's Court of the County of Gaspé, at Ri vière-au-Renard; The Magistrate's Court of the County of L'Assomption, at L'Assomption; The Magistrate's Court of the County of L'Assomption, at Laurentides; The Magistrate's Court of the County of Labelle, at Labelle; The Magistrate's Court of the County of Labelle, at Nominingue; The Magistrate's Court of the County of Labelle, at L'Annonciation; The Magistrate's Court of the County of Bellechasse, at St.Raphaël; The Magistrate's Court of the County of LTslet, at St.Jean-Port-Joli; The Magistrate's Court of the Town of Rigaud, at Rigaud; The Magistrate's Court of the County of Pontiac, at Chapeau; The Magistrate's Court of the County of Pontiac, at Quyon; The Magistrate'^ Court of the County of Pontiac, at Fort Coulonge; The Magistrate's Court of the County of Pontiac, at Shawville; The Magistrate's Court of the County of Yamaska, at St.François du Lac; The Magistrate's Court of the County of Lake St.John, at Hébert vil le Station; The Magistrate's Court of the County of Charlevoix, at Baie St.Paul; The Magistrate's Court of the County of Stanstead, at Stanstead-Plain; The Magistrate's Court of the County of Compton, at Cookshire; The Magistrate's Court of the Electoral District of Two Mountains, at St.Scholastique; The Magistrate's Court of the Electoral District of Two Mountains, at St.Eu s tache; The Magistrate's Court of the County of Terrebonne, at Terrebonne.We authorize the transmission of the records, registers, documents and archives of each of the said Magistrate's Courts thus abolished to the 1748 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 de la Cour dé magistrat du district judiciaire dont fait partie le comté ou le district électoral concerné.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable ONESIME GAGNON, CP., C.R., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce sixième jour de mai en l'année mil neuf cent cinquante-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la septième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la province, 47697-o JEAN BRUCHESI.Canada, Province de ONESIME GAGNON Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A M.Armand Boucher, marchand de Matane, président d'élection du district électoral de Matane.Salut.Nous vous ordonnons de faire faire, conformément à la loi et après qu'avis du jour et du lieu en aura dûment été donné, l'élection, dans le district électoral de Matane, pour remplacer l'honorable M.Onésime Gagnon, démissionnaire, et de fixer la présentation des candidats à cette élection au mercredi, le dix-huitième (18ème) jour de juin, 1958, et le scrutin, s'il y a lieu, au mercredi, le deuxième (2ème) jour de juillet, 1958, et de faire à notre président général des élections, à Québec, aussitôt que possible et au plus tard mercredi, le seizième (1 berne) jour de juillet, 1958, un rapport lui faisant connaître le nom du candidat qui aura été élu.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre Province de Québec.'Témoin: Notre fidèle et bien-aimé l'honorable ONESIME GAGNON, CP., C.R., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le septième (7ème) jour de mai, en l'an de grâce 1958, et de Notre règne la septième année.Par ordre, Le Président général des élections; 47736-o FRANÇOIS DROUIN, C.R.office of the clerk of the Magistrate's Court of the judicial district of which the county or electoral district concerned forms part.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable ONESIME GAGNON, P.C., Q.C., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this sixth day of May, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-eight and the seventh year of Our Reign: By command, JEAN BRUCHESI, 47697 Under Secretary of the Province.Canada, Province of ONÉSIME GAGNON Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To Mr.Armand Boucher, merchant of Matane, Returning-Officer for the electoral district of Matane.Greeting.We command you that, after notice of time and place of election being duly given, you do cause election to be made according to law, in the electoral district of Matane, in order to replace the Honourable Mr.Onésime Gagnon, resigner, and that you do cause the nomination of candidates of such election to be held on Wednesday, the eighteenth (18th) day of June 1958, and polling, if necessary, on Wednesday, the second (2nd) day of July, 1958, and as soon as possible and at the latest Wednesday, the sixteenth (16th) day of July, 1958, report to our Chief Returning-Officer, at Quebec, informing him of the name of the elected candidate.In testimony whereof, We have caused the Our letters to be made patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable ONESIME GAGNON, P.C., Q.C., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this seventh (7th) day of May, in the year of Our Lord' 1958, and the seventh year of Our Reign.By command, FRANÇOIS DROUIN, Q.C., 47736-0 Chief Returning-Officer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1749 Sièges sociaux Canada \u2014Province de Québec District de Montreal Dans l'affaire de: Candiac Construction Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Candiac Construction Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 28e jour de février 1958, et ayant son siège social à Ville Mont-Royal, en ladite province, a établi son bureau à 5665 rue Paré en ladite ville.A compter de la date de cet avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 24e jour de mars 1958.(Sceau) Le Secrétaire, 47703 GILLES DORÉ.Avis de changement d'adresse du bureau principal \"Les Placements Alvic Inc.\" Avis est donné que la compagnie \"Les Placements Alvic Inc.*, constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 mai 1957 et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 132 de la rue St-Jacques ouest, l'a transporté au numéro 261 de la rue St-Jacques ouest.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Montréal, le 27 mars 1958.Le Secrétaire, 47704-o GUY DESJARDINS.Canada \u2014 Province dé Québec District de Montréal Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability).\"Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd.\", No Personal Liability, déclare qu'elle a transporté son siège social et principale place d'affaires de 266 ouest, rue St-Jacques, en la cité de Montréal, à 637 ouest, rue Craig, en ladite cité.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 28e jour d'avril 1958.Le Président, 47711 H.M.AMSLER.Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal » _ Pennbec Mining Corporation (No Pergonal Liability) \"Pennbec Mining Corporation\", No Personal Liability, déclare qu'elle a transporté son siège social et principale place d'affaires de 266 ouest, rue St-Jacques, en la cité de Montréal, à 637 ouest, rue Craig, en ladite cité.A compter de Head Offices Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal In the matter of: Candiac Construction Ltd.Notice is hereby given that \"Candiac Construction Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 28th day of February, 1958, and having its head office in the Town of Mount Royal, in the said Province, has established its office at 5665 Paré Street, in the said town.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being-the head office of the Company.Dated at Montreal, this 24th day of March, 1958.(Seal) GILLES DORÉ, 47703-o Secretary.Notice of change of address from the Head Office \"Les Placements Alvic Inc.\" Notice is hereby given that the company \"Les Placements Alvic Inc.\", incorporated by letters patent dated May 24, 1957 and having its head office in the city of Montreal, where its office has been situated until this date, at number 132 St-James Street, West, has transferred it to number 261 St-Jacques Street, West.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Montreal, March 27, 1958.GUY DESJARDINS, 47704 Secretary.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) \"Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd.\", No Personal Liability, declares that it has moved its head office and principal place of business from 266 St.James Street, West, in the City of Montreal to 637 Craig Street, West, in the said City.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 28th day of April, 1958.H.M.AMSLER, 47711-0 President.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Pennbec Mining Corporation (No Personal Liability) \"Pennbec Mining Corporation\", No Personal Liability, declares that it has moved its head office and principal place of business from 266 St.James Street, West, in the City of Montreal to 637 Craig Street, West, in the said City 1750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1958, Tome 90, N° 19 la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 28e jour d'avril 1958.Le Président, 47712 H.M.AMSLER.Avis est donné que la compagnie \"Caprive Oil and Gas Company Limited\" (N.P.L.) constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 avril 1957.et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, a établi son bureau au N° 3539 Avenue du Parc.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 30ièmc jour d'avril 1958.Le Président, 47741-0 MAX SURKIS.Soumissions La Cité de Québec AVIS PUBLIC lie Greffier de la Cité recevra d'hui au 14 mai 1958 à 10 heures a.m.(heure avancée) des soumissions cachetées pour l'achat d'obligations de la Cité de Québec, pour un montant global de $2,301,000.00 datées du 1er mai 1958, remboursables par séries pendant une période de vingt ans et suivant les règlements numéros 1073, 1074, 1075 et 1076 de ladite cité.Pour plus amples renseignements et formules de soumission, s'adresser au Trésorier de la Cité.Daté à Québec, ce 5ième jour de mai 1958.Le Greffier de la cité, 47713-0 F.X.CHOUINARD.CORRECTION Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Beauport (Comté de Québec) On est prié de noter que l'ouverture des soumissions pour la vente de $478,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Beauport, dans l'avis paru dans la Gazette officielle du 3 mai 1958, à la page 1676, est remise de lundi le 19 mai à jeudi le 22 mai.47729-0 Province de Québec Village de Pincourt (Comté de Vaudreuil) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-B.Lamarre, N.P., secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 heures du soir, à 20 rue de l'Église, Dorion, comté de Vaudreuil, ou jusqu'à 8.00 heures du soir, au soubassement de 1 église, de Notre-Dame-de-Lorette-de-Pincourt, Pincourt, comté de Vaudreuil, lundi, le 26 mai 1958, pour l'achat de $38,000.00 d'obh'gations du village de From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 28th day of April, 1958.H.M.AMSLER, 47712-o President.Notice is hereby given that \"Caprive Oil and Gas Company Limited\" (N.P.L.) company incorporated by letters patent on April 17th 1957, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 3539 Park Avenue.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.\u2022 Dated at Montreal, this 30th day of April 1958.MAX SURKIS, 47741-0 President.Tenders The City of Quebec PUBLIC NOTICE The City Clerk will receive as from this date to the 14th of May, 1958 at 10 o'clock a.m., (Daylight Saving Time) sealed tenders for the purchase of bonds of the City of Quebec, for a global amount of $2,301,000.00 dated May 1st, 1958, redeemable serially during a period of twenty years and according to by-laws numbers 1073, 1074, 1075 and 1076 of the said City.For more ample information and forms for tenders, apply to the City Treasurer.Dated at Quebec, May 5th, 1958.F.X.CHOUINARD, 47713 City Clerk.CORRECTION The school commissioners for the municipality of thé town of beauport ' (County of Quebec) Please note that the opening of tenders for the sale of $478,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of the town of Beauport, in the notice that appeared in the Quebec-Official Gazette of May 3rd, 1958, at page 1676, shall take place on Thursday, May 22nd, instead of Monday, May 19th.47729-0 Province of Quebec Village of Pincourt (County of Vaudreuil) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-B.Lamarre, N.P., Secretary-Treasurer, until 7.30 o'clock p.m., at 20 Church St., Dorion, county of Vaudreuil, or until 8.00 o'clock p.m., in the basement of the Notre - Dame- de -Lorette- de -Pincourt Church, Pincourt, county of Vaudreuil, Monday, May 26,1958 for the purchase of an issue of $38,000.00 of bonds of the Village of Pincourt, county of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1958, Vol.90, No.19 1751 Pincourt, comté de Vaudreuil, datées du 1er juin 1058 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur À 5% par année, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 48 \u2014 travaux de voirie.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $38,000.00 \u2014 20 ans Annie Capital 1er juin 1959.11,000.00 1er juin 1960.1,000.00 1er juin 1961.1,000.00 1er juin 1962.1,500,00 1er juin 1963.1,500.00 1er juin 1964.*.1,500.00 1er juin 1965.1,500.00 1er juin 1966.1,500.00 1er juin 1967.1,500.00 1er juin 1968 .2,000.00 1er juin 1969.2,000.00 1er juin 1970 .2,000.00 1er juin 1971.2,000.00 1er juin 1972 .2,000.00 1er juin 1973.2,500.00 1er juin 1974.2,500.00 1er juin 1975 .2,500.00 1er juin 1976 .2,500.00 1er juin 1977 .3,000.00 1er juin 1978 .3,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Dorion, comté de Vaudreuil.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 26 mai 1958, à 8.00 heures du soir, au soubassement de l'église de Notre-Dame-de-Lorette-de-Pincourt, Pincourt, comté de Vaudreuil.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pincourt, (Comté de Vaudreuil), ce 6 mai 1958.Le Secrétaire-trésorier, J.-B.LAMARRE, N.P.Adresse postale: 20 rue de l'Église, Dorion, (Vaudreuil), P.Q.Téléphone: 3-424.47728-o Vaudreuil, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.48 \u2014 work on roads.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from June 1st, 1958.The table of redemption is as follows : Table of redemption \u2014 838,000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1959.$1,000.00 June 1st, 1960.1,000.00 June 1st, 1961.1,000.00 June 1st, 1962.1,500.00 June 1st, 1963.1,500.00 June 1st, 1964.:.1,500.00 June 1st, 1965.1,500.00 June 1st, 1966.1,500.00 June 1st, 1967.1,500.00 June 1st, 1968.2,000.00 June 1st, 1969.2,000.00 June 1st, 1970.2,000.00 June 1st, 1971.2,000.00 June 1st, 1972.2,000.00 June 1st, 1973.2,500.00 June 1st, 1974.2,500.00 June 1st, 1975.2,500.00 June 1st, 1976.2,500.00 June 1st, 1977.3,000.00 June 1st, 1978.3,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Dorion, county of Vaudreuil.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before June 1st, 1968, inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be .accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, May 26, 1958, at 8.00 o'clock p.m., in the basement of the Notre-Dame-de-Lorette-de-Pincourt, Pincourt, county of Vaudreuil.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Pincourt, (County of Vaudreuil), May 6th, 1958.J.-B.LAMARRE, N.P., Secretary-Treasurer.Postal address: 20 Church Street, Dorion, (Vaudreuil), P.Q.Telephone: 3-424.47728 \\ ¦ Province de Québec Les syndics d'écoles protestantes pour la municipalité de mur do ch ville (Comté de Gaspé-Nord) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Beverley D.Veale, secrétaire-trésorier, Murdochville, comté de Gaspé-Nord, jusqu'à 8.00 heures p.m., lundi le 26 mai 1958, pour l'achat de $256,000.00 d'obligations des syndics d'écoles protestantes pour la municipalité de Murdochville, comté de Gaspé-Nord, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année payable semi-annuel-lement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.* Aux fins de l'adjudication de cette émission, le calcul de l'intérêt sera effectué à compter du 1er juin 1958.Résolution d'emprunt datée du 6 août 1956 \u2014 construction d'une école.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $256,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1959.x $16,000.00 1er juin 1960.x 17,000.00 1er juin 1961.x 18,000.00 1er juin 1962.x 18.-500.00 1er juin 1963.x 19,500.00 1er juin 1964.x 20,500.00 1er juin 1965.x 21,500.00 1er juin 1966.x 22,500.00 1er juin 1967.6,500.00 1er juin 1968 .7,000.00 1er juin 1969 .7,000.00 1er juin 1970.7,500.00 1er juin 1971.8,000.00 1er juin 1972 .8,000.00 1er juin 1973.8,500.00 1er juin 1974.'.9,000.00 1er juin 1975 .9,500.00 1er juin 1976.10,000.00 1er Juin 1977.10,500.00 1er juin 1978.11,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi de $138,-815.59 accordé par le Secrétaire de la province et payable en huit versements dont un de $17,352.01 et sept de $17,351.94 chacun, de 1959 à 1966 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Murdochville, comté de Gaspé-Nord.\u2022 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est indiqué dans la procédure d'emprunt et au siège social de la même banque à Toronto.* Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette dernière date lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partie], il affectera les échéances les Province of Quebec The protestant school trustees for the municipality of Murdochville (County of Gaspé-North) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Beverley D.Veale, Secretary-Treasurer, Murdochville, county of Gaspé-North, until 8.00 o'clock p.m., Monday, May 26th, 1958, for the purchase of an issue of $256,000.00 of bonds of the protestant school trustees for the municipality of Murdochville, county of Gaspé-North, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.For the purposes of awarding the issue, computation of interest will be made as from June 1st, 1958.Loan resolution dated August 6th, 1956 \u2014 construction of a school.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $266,000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1959.x $16,000.00 June 1st, 1960.*x 17,000.00 June 1st, 1961.x 18,000.00 June 1st, 1962.x 18,500.00 June 1st, 1963.x 19,500.00 June 1st, 1964.x 20,500.00 June 1st, 1965.x 21,500.00 June 1st, 1966.x 22,500.00 June 1st, 1967.6,500.00 June 1st, 1968.7,000.00 June 1st, 1969.7,000.00 June 1st, 1970.7,500.00 June 1st, 1971.8,000.00 June 1st, 1972.8,000.00 June 1st, 1973.8,500.00 June 1st, 1974.9,000.00 June 1st, 1975.9,500.00 June 1st, 1976.10,000.00 June 1st, 1977.10,500.00 June 1st, 1978.11,000.00 The \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $138,815.59, granted by the Provincial Secretary and payable in eight instalments, that is one of $17,352.01 and seven of $17,351.94 each, from 1959 to 1966 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Murdochville, county of Gaspé-North.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, and at the main office of the same bank in Toronto.The said bonds shall not be redeemed by anticipation before June 1st, 1968 inclusively; after the latter date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be 1752 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.10 mai 1968, Tome 90, N° 19 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1753 plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des syndics d'écoles proptestantes qui sera tenue lundi le 26 mai 1958 à 8.00 heures p.m., à l'école protestante de Murdochville, Murdochville, comté de Gaspé-Nord.Les syndics d'écoles protestantes se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Murdochville, (Comté de Gaspé-Nord), ce 6 mai 1958.Le Secrétaire-trésorier, BEVERLEY D.VEALE.Murdochville, (Comté de Gaspé-Nord)r P.Q.Téléphone: 3219.47730 called for payment in reverse onder of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the protestant school trustees to be held on Monday, May 26th, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Murdochville protestant school, Murdochville, county of Gaspé-North.The protestant school trustees do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Murdochville, (County of Gaspé-North), this 6th of May, 1958.BEVERLEY D.VEALE, Secretary-Treasurer.Murdochville, (County of Gaspé-North), P.Q.Telephone: 3219.47730-o Province de Québec Ville de Greenfield Park Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-H.Page, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 206 Boulevard Churchill, Greenfield Par, jusqu'à 8.00 heures du soir, jeudi, le 29 mai 1958, pour l'achat de $489,000 d'obligations de la ville de Greenfield Park, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4}^% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellemcnt les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunt numéros 195 \u2014 $77,-000.00, trottoirs, drainage et pavage; 200 \u2014 $158,000.00 \u2014 drainage, trottoirs, pavage, éclairage; 202 \u2014 $36,000.00 \u2014 travaux d'égouts; 203 \u2014 $16,000.00 \u2014travaux d'égouts; 204 \u2014$12,-000.00 \u2014 travaux d'égouts; et 210 \u2014 $190,000.00 \u2014 égouts, aqueduc, trottoirs, pavage, éclairage de rues.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement: $489,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1959.$16,000.00 1er juin 1960.16,000.00 1er juin 1961.17,000.00 1er juin 1962.18,000.00 1er juin 1963.19,000.00 1er juin 1964.20,000.00 1er juin 1965.21,000.00 1er juin 1966.22,000.00 1er juin 1967 .23,000.00 1er juin 1968.24,000.00 1er juin 1989.25,000.00 1er juin 1970 .26,000.00 1er juin 1971.26,000.00 1er juin 1972.\u201e.27,000.00 1er juin 1973.28,000.00 1er juin 1974.30,000.00 1er juin 1975.31,000.00 1er juin 1976 .32,000.00 1er juin 1977 .33,000.00 1er juin 1978 .35,000.00 Province of Quebec Town of Greenfield Park Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-H.Page, Secretary-Treasurer, Town Hall, 206 Churchill Boulevard, Greenfield Park, until 8.00 o'clock, p.m.Thursday, May 29, 1958, for the pourchase of an issue of $489,000 of bonds of the Town of Greenfield Park, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4/^2% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-laws numbers 195 \u2014 $77,000.00, sidewalks, drainage and paving; 200 \u2014 $158,000.00 \u2014 drainage, sidewalks, paving, lighting; 202 \u2014 $36.000.00 work on sewers; 203 \u2014$16,000.00\u2014 work on sewers; 204 \u2014 $12,000.00 \u2014work on sewers; and 210 \u2014 $190,000.00 \u2014 sewers, aqueduct, sidewalks, paving, street lighting.For purposes of adjudication only, interest shall be computed as from June 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $489,000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1959.$16,000.00 June 1st, 1960.\".16,000.00 June 1st, 1961.17,000.00 June 1st, 1962.18,000.00 June 1st, 1963.19,000.00 June 1st, 1964 .20,000.00 June 1st, 1965 .21,000.00 June 1st, 1966 .22,000.00 June 1st, 1967.23,000:00 June 1st, 1968.24,000.00 June 1st, 1969.-.25,000.00 June 1st, 1970 .26,000.00 June 1st, 1971.26,000.00 June 1st, 1972.27,000.00 June 1st, 1973.28,000.00 June 1st, 1974.-.30,000.00 June 1st, 1975 .31,000.00 June 1st, 1976 .32,000.00 June 1st, 1977 .33,000.00 June 1st, 1978.35,000.00 1754 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Lambert, comté de Chambly.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue jeudi, le 29 mai 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de ville, 206 Boulevard Churchill, Greenfield Park.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Greenfield Park, ce 7 mai 1958.Le Secrétaire-trésorier, J.-H.PAGE.Hôtel de Ville, 206, Boulevard Churchill, Greenfield Park, P.Q.Tél.: ORléans 1-7347.47742-o The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St-Lambert, county of Chambly.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank at Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before June 1st, 1968 inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Thursday, May 29, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, 206 Churchill Boulevard, Greenfield Park.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Greenfield Park, this May 7th, 1958.J.-H.PAGE, Secretary-Treasurer.Town Hall, 206 Churchill Boulevard, Greenfield Park, P.Q.Tel.: ORleans 1-7347.47742 Province de Québec Ville de Matane Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-E.Dionne, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 207 avenue St-Jérôme, Matane, jusqu'à 8.00 heures du soir, vendredi, le 30 mai 1958, pour l'achat de $220,000.00 d'obligations de la ville de Matane, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4}^% ni supérieur à 5% par année, payable se mi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 289 \u2014 construction de barrages, puits Layne, travaux d'aqueduc et d'égouts, de voirie, construction de trottoirs, etc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $220,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1959.$ 6,500.00 1er juin 1960.6,500.00 1er juin 1961.7,000.00 1er juin 1962 .7,500.00 1er juin 1963 .8,000.00 1er juin 1964 .8,500.00 1er juin 1965 .8,500.00 1er juin 1966.9,000.00 1er juin 1967 .9,500.00 1er juin 1968.10,000.00 Province of Quebec Town op Matane Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-E.Dionne, Secretory-Treasurer, Town Hall, 207 St-Jérôme, Matane, until 8.00 o'clock p.m., Friday, May 30, 1958, for the purchase of an issue of $220,000.00 of bonds of the town of Matane, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate of not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.289 \u2014 the building of a dam, Layne wells, work on aqueduct and sewers, work on roads, the building of sidewalks, etc.For purposes of adjudication only, interest shall be computed as from June 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $220,000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1959.$ 6,500.00 June 1st, 1960.6,500.00 June 1st,-1961.7,000.00 June 1st, 1962.7,500.00 June 1st, 1963.8,000.00 June 1st, 1964.8,500.00 June 1st, 1965.8,500.00 June 1st, 1966.9,000.00 June 1st, 1967.9,500.00 June 1st, 1968.10,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1755 leriuin:i969.11,000.00 1er juin 1970.11,500.00 1er juin 1971.12,000.00 1er juin 1972.12,500.00 1er juin 1973.13,500.00 1er juin 1974.14,000.00 1er juin 1975.15,000.00 1er juin 1976.15,500.00 1er juin 1977.16,500.00 1er juin 1978.17,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Matane.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne Seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être1 accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue vendredi, le 30 mai 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, 207 avenue St-Jérôme, Matane.Le conseil se réserve le droit de_n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Matane, ce 7 mai 1958.Le Secrétaire-trésorier, J.-E.DIONNE.Hôtel de Ville, 207 avenue St-Jérôme, Matane, P.Q.Téléphone: 176.47743-o June 1st, 1969.11,000.00 June 1st, 1970.11,500.00 June 1st, 1971.12,000.00 June 1st, 1972.12,500.00 June 1st, 1973.13,500.00 June 1st, 1974.14,000.00 June 1st, 1975.15,000.00 June 1st, 1976.15,500.00 June 1st, 1977.16,500.00 June 1st, 1978.17,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Matane.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank at Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before June 1st, 1968 inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.i Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Friday, May 30, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, 207 St-Jérôme, Matane.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Matane, May 7th, 1958.J.E.DIONNE, Secretary-Treasurer.Town Hall, 207 St-Jérôme Avenue, Matane, P.Q.Telephone: 176.47743 Province de Québec Cité de St-Hyacinthe Avis publicist par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pouf obligations\" seront reçues par le soussigné, Jean-Paul Brault, greffier, Hôtel de Ville, 700 rue Hôtel de Ville, St-Hyacinthe, jusqu'à 8.00 heures du soir, jeudi, le 29 mai 1958, pour l'achat de $225,-000.00 d'obligations de la cité de St-Hyacinthe, datées du 1er mai 1958 et remboursables par séries du 1er mai 1959 au 1er mai 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuelle-ment les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 750 \u2014 travaux de voirie, d'aqueduc et d'électricité et achat et aménagement d'un terrain de stationnement.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er juin 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $225,000.00 \u2014 20 ans Annie Capital 1er mai 1959.$ 7,000.00 1er mai 1960.7,000.00 Province of Quebec City of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jean-Paul Brault, city clerk, City Hall, 700 City Hall Street, St.Hyacinthe, until 8.00 o'clock p.m., Thursday, May 29,1958, for the purchase of an issue of $225,000-.00 of bonds of the city of St.Hyacinthe, dated May 1st, 1958 and redeemable serially from May 1st, 1959 to May 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate of not less than 4% or more than 5% per annum, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan By-law No.750 \u2014 Road labour, waterworks and electricity, purchase of land and arrangement thereof for parking purposes.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from June 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $226,000.00 \u2014 20 years Year Capital May 1st, 1959 .$ 7,000.00 May 1st, 1960 .7,000.00 1756 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 1er mai 1961.8,000.00 1er mai 1962.8,000.00 1er mai 1963.8,000.00 1er mai 1964.8,000.00 1er mai 1965.10,000.00 1er mai 1966.10,000.00 1er mai 1967.10,000.00 1er mai 1968.10,000.00 1er mai 1969.12,000.00 1er mai 1970.12,000.00 1er mai 1971.12,000.00 1er mai 1972.12,000.00 1er mai 1973.14,000.00 1er mai 4974.14,000.00 1er mai 1975.15,000.00.1er mai 1976.15,000.00 1er mai 1977.15,000.00 1er mai 1978.18,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Hyacinthe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le' 1er mai 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue jeudi, le 29 mai 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, 700 rue Hôtel de Ville, St-Hyacinthe.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumission.St-Hyacinthe, ce 7 mai 1958.Le Greffier, JEAN-PAUL BRAULT.Hôtel de Ville, 700, rue Hôtel de Ville, St-Hyacinthe, P.Q.Téléphone: PRovince 4-5341.47744-o May 1st, 1961 .8,000.00 May 1st, 1962 .8,000.00 May 1st, 1963 .8,000.00 May 1st, 1964 .8,000.00 May 1st, 1965 .10,000.00 May 1st, 1966 .10,000.00 May 1st, 1967 .10,000.00 May 1st, 1968 .10,000.00 \u2022 May 1st, 1969 .12,000.00 May 1st, 1970 .12,000.00 May 1st, 1971 .12,000.00 May 1st, 1972 .12,000.00 May 1st, 1973 .14,000.00 May 1st, 1974 .14,000.00 May 1st, 1975 .15,000.00 May 1st, 1976 .15,000.00 May 1st, 1977 .15,000.00 May 1st, 1978 .18,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St.Hyacinthe.Capital and interest are payable at all branches of the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as the head office of said bank in Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to May 1st, 1958 inclusive; after which date, the said bonds may, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemad by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each terder must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at à meeting of the Council to be held on Thursday, May 29, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the City Hall, 700 City Hall Street, St.Hyacinthe.The Council is not bound to accept the highest or any of the tenders.St.Hyacinthe, this May 7, 1958.JEAN-PAUL BRAULT, City-Clerk.City HaU, 700, City Hall street, St-Hyacinthe, P.Q.Telephone: PRovince 4-5341.47744 Ventes \u2014 Loi de faillite Sales \u2014 Bankrupcy Act Canada, Province de Québec, district de Canada, Province of Quebec, district of Que-Québec, N° 5548-F.Dans la Cour Supérieure bec, No.5548-F.In the Superior Court (In (En matière de faillite).Dans l'affaire de: .Bankruptcy).In the matter of: Roméo Dumont, Roméo Dumont, cultivateur, de St-Êleuthère, farmer, of St-Êleuthère, county of Kamouraska, comté de Kamouraska, P.Q.P.Q.VENTE A L'ENCAN Avis est par les présentes donné que SAMEDI, le VINGT-QUATRIÈME jour de MAI, 1958, à ONZE heures et TRENTE a.m.sera vendu par encan public à la porte de l'église paroissiale de St-Éleuthère, comté de Kamouraska, P.Q., l'immeuble ci-après décrit, savoir: Les lots de terre connus sous les numéros 14-A et 14-B du cadastre officiel pour le huitième rang du canton Pohénégamook, comté de Kamouraska, avec les bâtisses dessus construites.AUCTION SALE Notice is hereby given that on SATURDAY, MAY TWENTY-FOUR, 1958, at ELEVEN THIRTY o'clock a.m., will be sold by public auction, at the church door of the parish of St-Éleuthère, county of Kamouraska, P.Q., the immoveable property as follows: Lots of land known under the numbers of 14A and 14-B of the official cadastre for the 8th range for district of Pohenegamook, county of Kamouraska, with the building hereon erected. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1757 Cet immeuble sera vendu au plus haut et dernier enchérisseur à la charge des taxes municipales et scolaires et de toutes autres impositions foncières tant pour le passé que pour l'avenir.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux du syndic soussigné.Cette vente sera faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code de procédure civile et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite.< Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: Argent comptant.Québec, ce 14 avril, 1958.Le Syndic, .J.P.BÊDARD.Bureaux: 71, rue St-Pierre, Chambre 411, Québec.47559-16-2-0 Province de Québec, district de Joliette, Cour Supérieure, en faillite, N° 670.Dans l'affaire de la faillite de Wilfrid Dufort,.domicilié et demeurant à Saint-Sulpice, district de Joliette, débiteur.Avis public est par les présentes donné qu'en vertu d'une ordonnance du Tribunal rendue le 4ième jour de mars 1958, je vendrai les immeubles ci-après décrits par encan public avec effet du décret: \"Trois lots de terre sur la cote est de la 42ième Avenue, en la ville de Pointe-aux-Trembles, connus et désignés sous le numéro mille quarante-quatre, mille quarante-cinq et mille quarante-six, de la subdivision officielle du lot originaire deux cent six (206-1044, 1045, 1046) aux plans et livres de renvoi officiels de la paroisse de Pointeaux-Trembles, avec bâtisses dessus construites, portant le numéro civique de ladite 42ième Avenue.\" Pour être vendu à l'enchère publique au bureau du Sheriff, au nouveau Palais de Justice, 100 est, rue Notre-Dame, le VINGT-HUITIEME jour de MAI 1958, à DEUX heures TRENTE de l'après-midi.Conditions: comptant ou à la satisfaction du syndic.Pour autres renseignements et cahier de charges, s'adresser au soussigné.Montréal, ce dix-huitième jour d'avril 1958.Le Syndic, J.G.FERN AND BISSONNETTE.Bureau: J.G.FERN AND BISSONNETTE, 152 rue Notre-Dame est, Chambre 12, Montréal, Tél.: UN-1-1554-1555.47639-17-2-o Ventes par licitation Canada, Province de Québec, district de Trois-Rivières, Cour Supérieure, N° 19-105, Armand Gauthier, journalier, des cité et district de Trois-Rivières, demandeur: vs Raoul Gauthier, Alice Gauthier, Philippe Livernoche, en sa qualité de curateur à sa fille Claudette, mineure émancipée, Roger Livernoche, René Livernoche, Jean-Roch Livernoche, tous des cité et district de Trois-Rivières; Alphonsine Gauthier, épouse commune en biens de Jack Flansberrv avec qui elle demeure en les cité et district' de Montréal, et ce dernier pour autoriser son épouse, et Dolorès Livernoche, épouse séparée de biens de Joseph E.DiBertolo avec qui elle demeure à Philadelphie, États-Unis d'Amérique, et ce dernier pour autoriser son épouse en autant que besoin est, défendeurs.This immoveable property shall be sold to the last and highest bidder subject to municipal and Scholar taxes and all impositions as much for the past as for the future.a Titles and certificates may be examined at all time by applying to the offices of the undersigned trustee.This sale shall be made in accordance with articles 716, 717 and 719A of the code of civil procedure and also article 55 of the bankruptcy act.This sale is equivalent to a sale by Sheriff.Conditions of payment: Cash.Quebec April 14th, 1958.J.P.BÊDARD, Trustee.Offices: 71, St-PeterSt., Room 411, Quebec.47559-16-2-0 Province of Quebec, district of Joliette, Superior Court, sitting in bankruptcy, No.670.In the matter of the, bankruptcy of Wilfrid Dufort, domiciled and residing at Saint-Sulpice, district of Joliette, debtor.Public notice is hereby given that by virtue of an order of the Court rendered the 4th day of March, 1958, I shall sell the immoveables hereinafter described by public auction with the effect of a sale by sheriff: \"Three lots of land on the east side of 42nd Avenue, in the town of Pointe-aux-Trembles, known and designated under number one thousand and forty-four, one thousand and forty-five, and one thousand and forty-six, of the official subdivision of original lot two hundred and six (206-1044, 1045, 1046) on the official flan and book of reference of the parish of binte-aux-Trembles, with buildings thereon erected, bearing civic number of said 42nd Avenue.\" To be sold by public auction at the Sheriff's office and the new Court House, 100 Notre-Dame Street, East, the TWENTY-EIGHTH day of MAY, 1958, at TWO-THIRTY o'clock in the afternoon.Conditions: cash or to the Trustee's satisfaction.For further information and list of charges, apply to the undersigned.Montreal, this eighteenth day of April, 1958.J.G.FERN AND BISSONNETTE, Trustee.Office: J.G.FERN AND BISSONNETTE, 152 Notre-Dame Street, East, Room 12, Montreal.Tel.: UN-1-1554-1555.47639-17-2 Sales by Licitation Canada, Province of Quebec, District of Trois-Rivières, Superior Court, No.19-105, Armand Gauthier, laborer, of the city and district of Trois-Rivières, plaintiff, vs Raoul Gauthier, Alice Gauthier, Philippe Livernoche, in his quality of Curator for his daughter, Claudette, of full age, Roger Livernoche, René Livernoche, Jean-Roch Livernoche, all of the city and district of Trois-Rivières; Alphonsine Gauthier, wife common as to property of Jack Flansberry with whom she lives in the city and district of Montreal, and the latter to authorize his wife, and Dolores Livernoche, wife separate as to property of Joseph E.DiBertolo, with whom she lives at Philadelphia, the United States of America, and the latter to authorize his wife inasmuch as is necessary, defendants. 1768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure,.siégeant à Trois-Rivières, dans le district de Trois-Rivières, le 21 avril 1958, dans la présente cause, ordonnant la lici-tation de l'immeuble désigné comme suit, savoir: \"Un emplacement situé sur la rue St-Philippe, en la cité des Trois-Rivières connu et désigné sous le lot quatre cent quarante (440) aux plan et livre de renvoi officiels de la cité des Trois-Rivières, avec une maison à deux logements portant les numéros civiques 2236 et 2238 de ladite rue, circonstances et dépendances.\" L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'en-, chère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le VINGT-SIXIÈME jour de JUIN 1958, Cour tenante, dans la salle d'audience du Palais de Justice de Trois-Rivières, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite Cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Les Trois-Rivières, le 29 avril 1958.Le Procureur du demandeur, 47674-18-2-o JACQUES LACOURSIÊRE.Canada, Province de Québec, district de Pontiac, Cour supérieure, N° 5924.Dame Ruby Latham, demanderesse; vs Dame Emma Latham et al, défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour supérieure siégeant à Campbell's Bay, district de Pontiac, rendu par le Juge H.A.Portier le 28 avril 1958 dans la cause où Dame Ruby Latham, de la ville de Clarkson, comté de Peel, province d'Ontario, épouse séparée de biens suivant les Lois de la province d'Ontario, de William N.Godda du même lieu, commis, assistée et autorisée par sondit époux aux fins des présentes en autant que cette assistance et autorisation sont requises par la Loi, est demanderesse, et Dame Emma Latham, de l'endroit appelé Bralorne, province de la Colombie Britannique, épouse de Henry Gréer du même lieu, Dame Annie Latham, de l'endroit appelé Tranquille, povince de la Colombie Britannique, épouse de Jake Quinton, du même lieu, Dame Rose Latham, de la cité de Timmins, province d'Ontario, épouse de Warren Roberts, du même lieu, et Charles Raymond Latham, autrefois du village de Shawville, district de Pontiac, ^et actuellement de lieux inconnus, sont les défendeurs, ordonnant la licitation de la propriété immobilière suivante, à savoir: \"Cette certaine propriété connue et désignée suivant les plan et livre de renvoi officiels du village de Shawville, district de Pontiac, comme étant le lot numéro cinquante-quatre (54), avec ensemble les bâtisses dessus érigées et tous les membres et dépendances y appartenant.\" NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at Trois-Rivières, in the district of Trois-Rivières, on April 21, 1958, in the present case, ordering the licitation of the immoveable designated as follows, wo wit: \"An emplacement situated on St-Philippe Street, in tng city of Trois-Rivières, known and designated under lot four hundred and forty (440) on the official plan and in the book of reference of the city of Trois-Rivières, with a two-tenement house bearing civic numbers 2236 and 2238 of the said Street, circumstances and dependencies.\" The immoveable above designated shall be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the TWENTY-SIXTH day of JUNE, 1958, in open court, in the Court Room of the Court House of Trois-Rivières, subject to the charges, clauses and conditions mentioned in the List of Charges filed in the Office of the Protonotary of the said Court; and that any opposition to annul, to « secure charges or to withdraw from the said licitation, must be filed in the of the Office of the Protonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and that any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; and in default by the interested parties to file the said opposition within the delays hereby prescribed, they shall be foreclosed from so doing.Trois-Rivières, April 29, 1958.JACQUES LACOURSIÊRE, 47674-18-2 Attorney for the plaintiff.Canada, Province of Quebec, district of Pontiac, Superior Court, No.5924.Dame Ruby Latham, plaintiff, vs Dame Emma Latham et al, defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a Judgment of the Superior Court sitting at Campbell's Bay, in the district of Pontiac, rendered by Mr.Justice H.A.Portier, on April 28th., 1958, in the case where Dame Ruby Latham, of the town of Clarkson, in the county of Peel, in the Province of Ontario, wife separate as to property according to the laws of the Province of Ontario, of William N.Godda, of the same place, clerk, hereto assisted and authorized by her said husband, in as much as such assistance and authorization' are required by law, is the plaintiff, and Dame Emma Latham, of the place called Bralorne, in the Province of British Columbia, wife of Henry Greer, of the same place, Dame Annie Latham, of the place called Tranquille, in the Province of British Columbia, wife of Jake Quinton, of the same place, Dame Rose Latham, of the City of Timmins, in the Province of Ontario, wife of Warren Roberts, of the same place and Charles Raymond Latham, formerly of the Village of Shawville, in the district of Pontiac and now of parts unknown, are the defendants, ordering the licitation of the following immoveable property, namely: \"That certain property known and designated according to the Official plan and in the book of reference for the Village of Shawville, in the district of Pontiac, as lot number fifty-four (54), together with the buildings thereupon erected and all members and appurtenances thereunto belonging.\" \\ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1759 L'immeuble ci-dessus sera vendu à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur le VINGT-TROISIÈME jour de JUIN 1958, à DIX heures et TRENTE du matin (10.30) au Palais de Justice à Campbell's Bay, au bureau du protonotaire, ladite vente sera sujette aux charges, clauses et conditions indiqués au cahier des charges déposé au bureau du protonotaire de ladite Cour; Toute opposition à afin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire, à ladite licitation devra être déposée au Greffe du Protonotaire, de ladite Cour, au moins douze jours, avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par les présentes, elles seront forcloses du droit de le faire.Un dépôt de cinq cents dollars ($500.00) sera exigé de tout offrant et enchérisseur.Campbell's Bay, 5 mai 1958.Le Procureur de la demanderesse, 47753-19-2 PAUL A.MARTINEAU.47753-19-2-o The above immoveable will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the TWENTY-THREE day of JUNE, 1958 at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon (10.30) at the Court House at Campbell's Bay, in the Prothonotary's office, the said sale to be made subject to the charges, clauses and conditions mentioned in list of charges filed in the office of the Prothonotary of the said Court; Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation, must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve (12) days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any opposition for payment must be filed within Six (6) days following the adjudication and failing, the interested parties to file such opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.A deposit of five hundred dollars ($500.00) shall be exacted from each and every bidder.Campbell's Bay, May the 5th, 1958.PAUL A.MARTINEAU, Attorney for the Plaintiff.Vente pour taxes AVIS PUBLIC Sals for Taxes PUBLIC NOTICE Avis est donnée par le soussigné secrétaire-trésorier de la ville de St-Félicien, que le HUIT MAI mil neuf cent cinquante-huit, à NEUF heure de l'avant-midi, en la salle de l'Hôtel de ville de St-Félicien, seront vendus à l'enchère les immeubles ou propriétées dont les taxes imposées n'ont pas été payées.Voici le détail de ces propriétés ou immeubles: Girard Edmourd, propriétaire lot 4-A-l, située sur la rue Boivin, du cadastre officiel du canton Desmeules pour taxes municipales: $268.05; taxes scolaires: $254.20.Potvin Roch, propriétaire lot 49A32, situé sur la rue St-Christophe, du 3ième rang, canton Ashuapmouchouan pour taxes municipales: $228.-65; taxes scolaires: $265.40.Potvin Wellie, propriétaire des lots N° 1A85 et l-A-96, coin Notre-Dame et rue Bouchard, 3ième* rang du canton Ashuapmouchouan, pour taxes municipales: $171.75; taxes scolaires: $105.05.Roy Thomas Louis, propriétaire des lots 4-A-5, situé sur la Plateau Boivin, faisant parti du canton Desmeules, pour taxes municipales: $581.90; taxes scolaires: $224.70.Numéro civique 6-8-10-12.Tremblay Leopold, fib Edm.-Ls., propriétaire des lots 4-A-16, situé sur le Blvd Projeté et la rivière Eusèbe partie du canton Desmeules, pour taxes municipales: $9.85; taxes scolaires: $12.25.Donné sous mon sein, à St-Félicien le vingt-trois avril mil neuf cent cinquante-huit.47668-18-2-o Le Secrétaire-trésorier, J.A.BLOUIN.Public notice is given by the undersigned Secretary-Treasurer of the town of St.Félicien, that the EIGHTH day of MAY, one thousand nine hundred and fifty-eight, at NINE o'clock in the forenoon, in the Hall of the City Hall of St.Félicien, shall be sold by auction the immoveables or properties fro the unpaid taxes imposed thereon.Herewith are details concerning said properties or immoveables: Girard Edmourd, owner of lot 4-A-l situate on Boivin Street, of the official cadastre of the township of Desmeules, for: municipal taxes; $268.05; school taxes: $254.20.Potvin Roch, owner of lot 49A32, situated on St.Christophe Street, range 3, township of Ashuapmouchouan for: municipal taxes: $228.65; school taxes: $265.40.Potvin Weliie, owner of lots No.1A85 and l-A-96, corner of Notre Dame and Bouchard Street, range 3, township of Ashuapmouchouan for: municipal taxes: $171.75; school taxes: $105.05.Roy Thomas Louis, owner of lots 4-A-5, situated on Boivin Plateau, forming part of the township of Desmeules for: municipal taxes: $581.90; school taxes: $224.70.Civic number 6-8-10-12.Tremblay Leopold, son Edm.Ls., owner of lots 4-A-16, situated on the proposed Blvd and Eusèbe River, part of the township of Des-meules for: municipal taxes: $9.85; school taxes: $12.25.Given under my seal, at St.Félicien the twenty-third day of April, one thousand nine hundred and fifty-eight.J.A.BLOUIN, 47668-18-2 Secretary-Treasurer. 1760 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, W19 VENTES PAR SHÉRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC, est par le présent donné que PUBLIC NOTICE, is hereby given that the les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect* respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.ABITIBI Province de Québec District de Beauce Cour Supérieure, e\\ XAURICE N ADE AU, N° 21,700.{ 1Vi manufacturier, de St.(.Bernard de Dorchester, de- ABITIBI Province of Quebec District of Beauce Superior Court, / \\ K AURICE N A D E A U.No.21,700.\\ AVI manufacturer, ofJtSt-v l Bernard de Dorchester, plain - mandeur, vs ELPHÉGE BROCHU, de Barraute, tiff vs ELPHÈGE BROCHU, of Barraute, dis-district d'Abitibi, défendeur, trict of Abitibi, defendnat.AVIS DE VENTE L'immeuble connu et désigné comme étant le lot N° 25 du rang 5, du cadastre officiel pour le canton Barraute, comté d'Abitibi-Est, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Barraute, le MERCREDI, VINGT ET UNIÈME jour de MAI 1958 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 10 avril 1958.47562-16-2-o NOTICE OF SALE The immoveable know and designated as being lot No.25 of range 5, of the official cadaster for the township of Barraute, county of Aibitibi-East, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies; To be sold at the parochial church door of Barraute, WEDNESDAY, MAY TWENTY-FIRST, 1958, at TWO o'clock in the afternoon.j.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, April 10, 1958.47562-16-2 GASPÉ Fieri Facias de Terri» Cour Supérieure, ( \\\\7TLFRID MORE AU, N° 4165.< VV Grande-Rivière, Ouest, vcomté de Gaspé, demandeur; contre LEO MOREAU, dit ASSELTN, Grande-Rivière, Ouest, comté de Gaspé, défendeur.La propriété à vendre est la suivante: \"Une certaine terre sise et située à Grande-Rivière, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels pour ladite municipalité comme étant le lot N° 160 du rang des 28 de la municipalité de Grande-Rivière, mesurant un arpent carré, avec maison dessus construite, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église de Grande-Rivière, MARDI le VINGTIEME jour de MAI 1958 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., 14 avril 1958.47567-16-2-0 GASPÉ Fieri Facias de Terri» Superior Court, ( \\\\ /LLFRID MOREAU, No.4165.{ VV Grande-Rivière, West, (county of Gaspé, plaintiff, against LÉO MOREAU, said ASSELTN, Grande-Rivière, West, county of Gaspé, defendant.The property for sale is the following: \"A certain farm situated at Grande-Rivière, known and designated on the official plan and in the book of reference for the said municipality as being lot No.160 of range of the 28 of the municipality of Grande-Rivière, measuring a square arpent, with house thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the church door of Grande-Rivière, TUESDAY, the TWENTIETH day of MAY, 1958, at TEN o'clock in the forenoon.j.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, P.Q., April 14» 1958.47567-16-2 Fieri Facias de Terris Cour de Magistrat, ( \"DANQUE DE TORON-Gaspé, )D TO DOMINION, de-N° 11193.^manaëur; vs VIATEUR (MÊTHOT, Montréal.La propriété à vendre est la suivante : \"Un certain morceau de terrain sis et situé dans la paroisse de Ste-Adelalde de Pabos, comté et district de Gaspé, mieux connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour la corporation municipale de Ste-Adélaïde de Pabos, comme étant partie du lot N° 38 du premier rang de la Seigneurie de Pabos, mesurant 100 pieds de largeur par 192 pieds de profondeur et étant borné comme suit: au nord par la route nationale, à l'ouest par la succession de Léon Duguay, au sud par le Golfe St-Laurent et à l'ouest par Mme James Hayes avec maison dessus construites circonstances et dépendances.\" Fieri Fada» de Terri» Magistrate's Court, f TY>MINION BANK OF Gaspé, )±J TORONTO, plain-No.11193.ïtiff; vs VIATEUR MÊ-(THOT, Montreal.The property to be sold is the following: \"A certain piece of land lying and situate in the parish of Ste.Adélaïde de Pabos, county and district of Gaspé, better known and designated on the official plan and book of reference for the municipal corporation of Ste.Adélaïde de Pabos, as being part of lot No.38 of range one of the Seigniory of Pabos, measring 100 feet in width by 192 feet in depth and being bounded as follows : northerly by the National Highway, westerly by the Estate of Léon Duguay, southerly by the Gulf of St.Lawrence and westerly by Mrs.James Hayes with house thereon erected, circumstances and dependencies. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Qusbec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1761 Pour être vendu à la porte de l'église de St-Adélalde de Pabos, MARDI le DIXIÈME jour de JUIN, 1958, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., ce 5 mai, 1968.47733-19-2-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure, ( ALBIN FAHEY, 5881 Gaspé, Avenue Durocher, N° 4797.\\ Montréal, Que., demandeur; l contre ROMUALD LAPOIN-TE, Petit-Pabos, Gaspé, Que., défendeur.La propriété à vendre est ta suivante: \"Une certaine terre sise et située dans la municipalité de Petit-Pabos, dans les comté et district de Gaspé, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels, pour ladite municipalité comme étant la demi ouest du lot 19, rang I de l'arpentage primitif de la Seigneurie de Pabos, correspondant au lot N° 19-B distraction faite du chemin de fer, rang I du cadastre officiel de la municipalité de Petit-Pabos, d'une superficie de 43 arpents carrés étant borné comme suit: au nord par le 2ième rang à l'est par James Shannon, au sud par le Golfe St-Laurent et à l'ouest par Albert Sutton avec bâtisses et dépendances\".Pour être vendue à la porte de l'église de Petit-Pabos, MARDI le DIXIÈME jour de JUIN, 1958, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., ce 5 mai, 1958.47734-19-2-o HULL Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure, )t À.MURDOCH, garagiste N° 26,545.>J \u2022 de Lachute, district de ; Terrebonne, demandeur, vs SYLVI01LANTHLER, gentilhomme de Masson, district de Hull, défendeur.\"Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro deux de la subdivision officielle du lot numéro huit du premier rang (No.8-2, Rg.I) du cadastre officiel du canton de Buckingham, d'une superficie totale de 50 acres, plus ou moins; à distraire toutefois les parties vendues comme suit: a) à Roger Malette, par vente enreg.sous numéroî68541 ; b) à Jean-Marie Rochon, par vente enreg.sous numéro 74448; e) à Alex Rotar, par vente enreg.sous numéro 74502; d) à Dame Théo.St.Jacques, par vente enreg.sous numéro 75275; e) à Dame Théo.St.Jacques, par vente enreg.sous numéro 75283; /) à Edgar Morin, par vente enreg.sous numéro 75358; g) à Jean-Jacques Richer, par vente enreg.sous numéro 76456; h) à Gaston Bronsard, par vente enreg.sous numéro 78115; \"Un terrain connu et désigné comme étant la partie Est du lot quatre de la subdivision officielle du lot numéro huit au cadastre officiel du premier rang du canton de Buckingham (P.E.8-4, rg.1), d'une superficie totale de 40.6 acres, plus ou moins, telle que-plus au long décrite suivant description faite le 5 décembre 1938 par S.E.Farley, A.G., et dans la déclaration de décès d'Alcide Lanthier, enreg.sous numéro 51528, bornée au To be sold at the door of the church of Ste.Adélaïde de Pabos, TUESDAY the TENTH day of JUNE 1958, at TEN o'clock in the afternoon.J.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, P.Q., May 5,1958.47733-19-2 Fieri Facias de Terris Superior Court, (ALBIN FAHEY, 5881 Gaspé, )Durocher Avenue, No.4797.) Montreal, Que., plaintiff; ver-' sus ROMUALD LAPOLNTE, Petit Pabos, Gaspé, Que., defendant.The property to be sold is the following: \"A certain piece of land lying and situate in the municipality of Petit Pabos, in the county and district of Gaspé, known and designated on the official plan and book of reference, for the said municipality as being the half west of lot 19, range I of the original survey of the Seigniory of Pabos, corresponding to lot No.19-B, excluding the Railroad, range I of the official municipality of Petit Pabos, of an area of 43 square arpents being bounded as follows: northerly by range 2, easterly by James Shannon, southerly by the Gulf of St.Lawrence and westerly by Albert Sutton with buildings and dependencies'.To be sold at the door of the church of Petit Pabos, TUESDAY the TENTH day of JUNE 1958, at TWO o'clock in the afternoon.J.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, P.Q., May 5, 1958.47734-19-2 HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, )T A.MURDOCH, garage-No.26,545.>J« keener, of Lachute, «fis-) trict of Terrebonne, plaintiff va SYLVIO LANTHLER, gentleman, of Masson, district of Hull, defendant.\"A piece of land known and designated as being lot number two of the official subdivision of lot number eight, range one (No.8-2, R.I) of the official cadastre of the township of Buckingham, of a total area of 50 acres, more or less; save and except however, those parts sold as follows: a) to Roger Malette, by deed of sale registered under number 68541; 6) to Jean-Marie Rochon, by deed of sale registered under number 74448; c) to Alex Rotar, by deed of sale registered under number 74502; d) to Dame Théo.St.Jacques, by deed of sale registered under number 75275; e) to Dame Théo.St.Jacques, by deed of sale registered under number 75283; f) to Edgar Morin, by deed of sale registered under number 75358; g) to Jean-Jacques Richer, by deed of sale registered under number 76456; h) to Gaston Bronsard, by deed of sale registered under number 78115; \"A piece of land known and designated as being the easterly part of lot four of the official subdivision of lot number eight of the official cadastre of range one of the township of Buckingham (P.E.8-4, R.1), of a total area of 40.6 acres, more or less, such as described at greater length in a description dated December 5, 1938, by S.E.Farley, L.S., and the declaration of the death of Alcide Lanthier, registered under number 51528, bound- 1762 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 nord par le lot 8-1, à l'ouest par le résidu dudit lot 8-4, rg.1, à l'est par les lots 8-3 ef8-2, et au sud parle lot 8-3 et la rivière Ottawa, avec toutes les bûtisses dessus construites, circonstances et dépendances\".Pour être vendus, en bloc, à la porte de l'église paroissiale Notre-Dame des Neiges, à Masson, district de Hull, le VINGT-TROISIÈME jour de MAI, 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-PLERRE.Hull, ce 15 avril, 1958.47593-16-2-o IBERVILLE Canada \u2014 Province de Québec District d'Iberville Cour de Magistrat, / TÊOPOLD BOU-N° 12047.\\ DREAU, rentier, do-Imicilié en la paroisse de Saint-Jean, district d'Iberville, demandeur, vs FERNAND FAFARD, domocilié à Mont St-Grégoire, district d'Iberville, défendeur, Comme appartenant au défendeur, savoir: \"Un morceau de terre situé en la paroisse de St-Grégoire-le-Grand, étant une partie du numéro trois cent quatre-vingt-six N° 386, du cadastre officiel de la paroisse de St-Athanase, contenant quatre-vingt-quatorze pieds anglais de largeur sur cent quatre-vingt pieds anglais à partir du chemin public du rang Kempt et borné au nord par ce chemin, à l'ouest par la partie dudit N° 386 appartenant à Lauréat Ducharme, au sud par la partie N° 386 restant au vendeur et à l'est par la partie N° 386 appartenant à un M.Savaria.Le tout avec bâtisses y érigées.\" Pour être vendue à là porte de l'église de la paroisse de St-Grégoire-le-Grand, district d'Iberville, VENDREDI, le VINGTIÈME jour de JUIN 1958, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.RICHARD MERCIER.Saint Jean, le 7 mai 1958.47745-19-2-o JOLIETTE Canada \u2014 Province de Québec District de Joliette Cour de Magistrat, (J A BANQUE PROVIN-N° 23,095.< Li CIALE DU CANA-vDA, corps politique et incorporé, ayant son siège social et sa principale place d'affaires dans les cité et district de Montréal, demanderesse et JAMES O.O'RYAN, de Côte St-Philippe, Mascouche, district de Joliette, défendeur.Comme appartenant au défendeur: \"Un terrain situé dans la paroisse de St-Henri de Mascouche, connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent soixante-dix (P.N° 570) du cadastre officiel de ladite paroisse; cedit terrain mesurant trois cent cinquante pieds de largeur, par cent vingt pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, est borné comme suit: en front, au sud, par une rue projetée, partie du même lot N° 570, appartenant à Monsieur Ralph L.Tedford, en arrière au nord, par le lot N° 572 appartenant à M.Terefenko, du côté ouest et du côté est, par partie du lot non détaché, appartenant à Monsieur Ralph L.Tedford, le tout au cadastre officiel sus-dit, avec les bâtisses dessus érigées.ed northerly by lot 8-1, westerly by the residue of said lot 8-4, R.1, easterly by lots 8-3 and 8-2, and southerly by lot 8-3 and the Ottawa River, with all buildings thereon erected, circumstances and dependencies\".To be sold \"en bloc\", at the door of the parochial church of Notre-Dame des Neiges, at Mas-son, district of Hull, the TWENTY-THIRD day of MAY 1958, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST-PLERRE, Sheriff's Office, Sheriff.HuU, this April 15, 1958.47593-16-2 IBERVILLE Canada \u2014 Province of Quebec District of Iberville Magistrate's Court, / TÊOPOLD BOU-No.12047.< L» DREAU, annuitant, I domiciled in the parish of Saint-John, district of Iberville, plaintiff vs FERN AND FAFARD, domiciled at Mont St.Grégoire, district of Iberville, defendant.As belonging to the defendant to wit: \"A piece of land situated in the parish of St.Grégoire-Ie-Grand, being a part of number three hundred and eighty-six No.386, of the official cadastre of the parish of St.Athanase, containing ninety-four feet, English measure, in width by one hundred and eighty feet, English measure, as from the public road of Range Kempt and bounded northerly by said road, westerly by that part of said No.386 belonging to Lauréat Ducharme, southerly by that part of No.386 remaining to the vendor and easterly by that part of No.386 belonging to a Mr.Savaria.All of which with buildings thereon erected.\" To be sold at the door of the church of the parish of St.Grégoire-le-Grand, district of R>er-ville, FRIDAY the TWENTD3TH day of JUNE 1958, at ELEVEN o'clock in the forenoon.RICHARD MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.Saint John, May 7, 1958.47745-19-2 JOLIETTE Canada \u2014 Province of Quebec District of Joliette Magistrate's Court, /nnHE PROVINCIAL No.23,095.< A BANK OF CANA-IDA, body politic and corporate, having its head office and its head office m the city and district of Montreal, plaintiff, and JAMES O.O'RYAN, of Côte St-Philippe, Mascouche, district of Joliette, defendant.As belonging to the defendant.\"A lot of land situated in the parish of St-Henri de Mascouche, known and designated as being a part of lot five hundred and seventy (Pt.No.570) on the official cadaster of the said parish; this said lot of land measuring three hundred and fifty feet in width, by one hundred and twenty feet in depth, English measure and more or less, is bounded as follows: in front, on the south, by the project of a planned street, part of the same lot No.570, belonging to Mr.Ralph Is.Tedford, in rear, on the north, by lot No.572, belonging to Mr.Terefenko, on the west side, and on the east side, by part of undetached lot, belonging to Mr.Ralph L.Tedford, the whole on the official cadaster abovesaid, with the buildings thereon erected. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1763 Tel que le tout se trouve présentement, avec les servitudes y attachées.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Henri de Mascouche, district de Joliette, MERCREDI le ONZIÈME jour de JUIN 1958, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif de Joliette, Bureau du Shérif, ROLAND PERRAULT.Joliette, ce 7 mai 1958.47747-19-2-0 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour Supérieure, / THOMAS RIOUX, taxi, de N° 20,352.< A Ste-Rose-du-Dégelé, de-Imandeur; vs JOSEPH E.PELLETIER, de Ste-Rose-du-Dégelé, défendeur.Une maison sise et située sur partie du lot 39, village de Sainte-Rose-du-Dégelé.Pour être vendue à la porte de l'église de Sainte-Rose-du-Dégelé, comté de Témiscouata, district de Kamouraska, JEUDI le DIX-NEUVIÈME jour de JUIN 1958, à DEUX heures de l'après-midi (heure avancée) Le Député-Shérif du Bureau du Shérif, district de Kamouraska, Rivière-du-Loup, CYRILLE PELLETIER, le 6 mai 1958.47732-19-2-0 [Première insertion: le 10 mai 1958] MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir:/t A CIE HENRI DE-N° 426719.-J-L» NIS LTÉE, demande-l resse, vs NORMAN CHAFFEE, défendeur.\"Un emplacement situé à St-Bruno, ayant front sur la rue Goyer, composé des lots nos 56 et 57 du lot originaire no 140 du cadastre de la paroisse de St-Bruno, tel que le tout se trouve présentement sans exception ni réserve.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Bruno, comté de Chambly, le TREIZIÈME jour de JUIN 1958, à ONZE heures du matin.Le Shérif, \u2022 CAISSE & Bureau du Shérif, LAURENCELLE.Montréal, 7 mai 1958.47750-19-2-o NICOLET Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec District de Nicolet Cour Supérieure, \"i t ^OFFICE DU CRÉDIT N° 2227.} L.AGRICOLE DU QUÊ-J BEC, corps politique et incorporé, ayant son siège social à Québec, demandeur; vs HENRI-PAUL CINQ-MARS, de R.R.I, Bécancourt, comté et district de Nicolet, défendeur; et J.ROGER LAFERRIÈRE, en sa qualité de syndic aux biens du cédant autorisé, présent défendeur, de 569, 5ième rue, Shawinigan Falls, comté de St-Maurice, mis-en-cause.1° Une terre située dans le deuxième rang du Canton de Maddington, de deux arpents et un 3uart de largeur sur vingt-huit acres de profon-eur, prenant devant au chemin public entre les As the whole is to be found presently, with the servitudes thereto attached.\" To be sold at the parochial church door of St-Henri de Mascouche, district of Joliette, WEDNESDAY, the ELEVENTH day of JUNE, 1958, at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERRAULT, Sheriff's Office, Sheriff of Joliette.Joliette, May 7, 1958.47747-19-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Superior Court, / THOMAS RIOUX, taxi-No.20,352.< ¦¦¦ driver of Ste-Rose-du-{Dégelé, plaintiff; vs JOSEPH E.PELLETIER, of Ste-Rose-du-Dégelé, defendant.A house situated on part of lot 39, village of Sainte-Rose-du-Dégelé.To be sold at the church door of Sainte-Rose-du-Dégelé, county of Temiscouata, district of Kamouraska, THURSDAY, the NINETEENTH day of JUNE, 1958, at TWO o'clock in the afternoon (Daylight Saving Time).CYRILLE PELLETIER, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff of the Rivière-du-Loup, district of Kamouraska.May 6th, 1958.47732-19-2 [First insertion: May 10, 1958] MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: (J A Cffi HENRI DE-No.426719.< L» NIS LTÉE, plaintiff, Us NORMAN CHAFFEE, defendant.\"An emplacement situated at St-Bruno, having frontage on Goyer Street, composed of lots Nos 56 and 57 of the original lot No.140 in the cadaster of the parish of St-Bruno, as the whole is presently to be found, without exception nor reserve.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St-Bruno, county of Chambly, on the THIRTEENTH day of JUNE, 1958, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, May 7, 1958.47750-19-2 V \u2014 NICOLET Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Nicolet Superior Court, \\ /QUEBEC FARM CREDIT No.2227.BUREAU, body politic / and corporate, having its head office at Quebec, plaintiff; vs HENRI-PAUL CINQ-MARS, of R.R.I, Bécancourt, county and district of Nicolet, defendant; and J.ROGER LAFERRIÈRE, in his quality of trustee of the goods of the authorized assignor, present defendant, of 569, 5th Street, Shawinigan Falls, county of St-Maurice, mis-en-cause.1.A farm situated in the second range of the Township of Maddington, of two arpents and one quarter in width by twenty-eight acres in depth, starting before the public road between a 1764 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1968, Tome 90, N9 19 premier et deuxième rangs dudit canton et allant se terminer en profondeur au chemin public du troisième rang du même canton; bornée au nord-est à Êvangéliste Légaré et au sud-ouest à Louis Dorion, cette terre étant la partie latérale et longitudinale nord-est du lot de terre numéro deux cent trente-trois, (P.N.E.233) du cadastre d'enregistrement du comté de Nicolet pour la paroisse de Ste-Gcrtrude; avec toutes les bâtisses sus-érigées.2° Un terrain prix et détaché du lot de terre numéro deux cent quatre-vingt-dix-huit du cadastre du comté de Nicolet pour la paroisse de Ste-Gertrude; d'un arpent et demi de largeur sur la profondeur du lot, prenant au chemin public dudit rang et aboutissant au Cordon du cinquième rang de Maddington, entre* Jimmy Vaillancourt vers l'ouest et Joseph Montam-bault vers l'est, en bois debout, sans bâtisse.3° Le lot de terre numéro trois cent cin- 3uante-huit (358) du cadastre officiel du comté e Nicolet, pour la paroisse de Bécancourt, contenant deux arpents, deux perches et quatorze pieds de front sur soixante arpents de profondeur, formant cent trente-six arpents et soixante-six perches en superficie, bornée en front et à l'ouest par le N° 344, en profondeur à l'est par la ligne limitative de la paroisse de Bécancourt, d'un côté au nord par le N° 343 et de l'autre côté au sud par les Nos 359 et 360, avec toutes les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.4° Un terrain à être pris et détaché du lot de terre numéro trois cent quarante-trois (343) du cadastre du comté de Nicolet, pour la paroisse de Bécancourt, situé au quatrième rang Dutord, des dimensions et compris dans les bornes et limites suivantes, savoir: ayant front à la petite rivière St-Louis, où il a un demi arpent de largeur et se continuant sur la même largeur vers le nord-ouest*, sur une profondeur de dix arpents, plus ou moins, jusqu'au résidu dudit lot N 343 appartenant à représentant MoTse Cham-poux, entre ce dernier au sud-ouest et Louis Leblanc ou représentant au nord-est.5° Un terrain à être pris et détaché du lot de terre numéro trois cent quarante-trois (P.343) du cadastre du comté de Nicolet pour la paroisse de Bécancourt, situé au quatrième rang Dutord, des dimension et compris dans les bornes et limites suivantes, savoir: ayant front à la petite Rivière St-Louis, où il a soixante-trois pieds, plus ou moins, de largeur et se continuant vers le nord-ouest sur une profondeur de dix arpents, plus ou moins, jusqu'au résidu dudit N° 343 appartenant déjà au donateur représentant Moïse Champoux, entre ce dernier au sud-ouest et Hector Morel ou représentant au nord-est.\" Pour être vendu \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de Bécancourt, le VINGT ET UNIÈME jour de MAI (1958) à' DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ANTONIO BLONDIN.Nicolet, 12 avril 1958.47566-16-2-0 QUÉBEC Fieri Farias Québec, à savoir: /t AURENTIDE AUTO-N° 91,435.< A-' MOBILES INC., corpo-( poration légale ayant son siège social à Québec, contre Dame ISABELLE the first and second ranges of the said Township and ending in depth at the public road of the third range of the same township; bounded on the northeast by Êvangéliste Légaré and on the south-west by Louis Dorion, the lateral and longitudinal part northeast of lot of land number two hundred and thirty-three, (Pt.N.E.233) of the registration cadaster of the county of Nicolet for the parish of Ste-Gertrude; with all the buildings thereon erected.2.A lot of land taken and detached from the lot of land number two hundred and ninety-eight of the cadaster of the county of Nicolet for the parish of Ste-Gertrude; of an arpent and one-half in width on the depth of the lot, starting from the public road of the said range and abutting at the Gordon of the fifth range of Maddington, between Jimmy Vaillancourt on the west and Joseph Montambault on the east, in timber, without building.3.\"Lot of land number three hundred and fifty-eight (358) of the official cadaster of the county of Nicolet, for the parish of Bécancourt, containing two arpents, two rods and fourteen feet in frontage by sixty arpents in depth, forming one hundred and thirty-six arpents and sixty-six rods in area, bounded on the front and on the west by No.344, in depth, on the east, by the limiting line of the parish of Bécancourt, on one side on the north, by No.343 and on the other side, on the south, by Nos.359 and 360, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.4.A farm to be taken and detached from the lot of land number three hundred and forty-three (343) of the cadaster of the county of Nicolet, for the parish of Bécancourt, situated in the fourth range Dutord, of the dimensions and comprised within the* following boundaries and limits, to wit: having frontage on \"petite rivière St-Louis\" with a width of one-half arpent and continuing in the same width on the northwest, along a depth of ten arpents, more or less, as far as the residue of the said'lot No.343, belonging to representative MoTse Champoux, between the latter on the southwest and Louis Leblanc or representative on the northeast.5.A lot of land to be taken and detached from lot of land number three hundred and forty-three (343) of the cadaster of the county of Nicolet for the parish of Bécancourt, situated on the fourth range Dutord, of the following dimensions and comprised within the following boundaries and limits, to wit: having frontage on the \"petite Rivière St-Louis\", where it has a width of sixty-three feet, more or less, and continuing along the northwest along a depth of ten arpents, more or less, as far as the residue of the said No.343 already pertaining to donor representing Moïse Champoux, between this latter on the southwest and Hector Morel or representative on the northeast.To be sold \"en bloc\" at the parochial church of Bécancourt, on the TWENTY-FIRST day of MAY (1958) at TEN o'clock in the forenoon.ANTONIO BLONDIN, Sheriff's Office, Sheriff.Nicolet, April 12, 1958.47566-16-2 QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : (T AURENTTDE AUTO-No.91,435.-J-L» MOBILES INC., legal v corporation having its head office in Quebec versus Dame ISABELLE VER- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1958, Vol.90, No.19 1765 VERMETTE, de Ste-Monique des Saules, veuve de feu Eugène Tremblay, en son vivant du même endroit, et BERNADETTE TREMBLAY, fille majeure et usant de ses droits, de Ste-Monique des Saules, conjointement et solidairement.\"Un morceau de terrain mesurant cinquante-six pieds (56') de front par sept pieds (7') de profondeur à prendre et à distraire du lot numéro soixante-six des subdivisions du lot originaire numéro dix (10-66 Ptie) du cadastre officiel de la paroisse de l'Ancienne-Lorette, comté de Québec, borné au nord par la Route Renaud, aujourd'hui Boulevard-Masson, au sud par le terrain ci-dessus décrit et des autres côtés par Monsieur Herménégilde Care au ou représentants; avec les maisons et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\"Un emplacement connu et désigné comme faisant partie du lot numéro dix (10 Ptie) du cadastre officiel pour la paroisse de l'Ancienne-Lorette, comté de Québec, mesurant quatre-vingt pieds (80*).de front, largeur sur la rue Renaud, aujourd'hui Boulevard Masson avec même largeur à sa ligne de profondeur sur cent vingt-cinq pieds (1250 de profondeur, mesure anglaise, borné au nord à la rue* Renaud, aujourd'hui Boulevard Masson, au sud-est et ouest à Gaudiose Madore ou représentants, le tout avec bâtisses et dépendances.\"Un terrain connu et désigné comme faisant partie- du lot numéro huit cent vingt-quatre (824 Ptie) du cadastre officiel de St-Ambroise de la Jeune Lorette, mesurant quatre-vingt-cinq pieds et cinq pouces (85' ô\") de largeur en front sur la route Val car tier, et cent pieds (1000 de largeur au bout de la profondeur sur cinq cent quarante pieds (5400 de profondeur, mesure anglaise, borné en front vers le sud-ouest par la Route Valcartier, en arrière vers le nord-est par le terrain d'Arthur Verret, au nord par le terrain de Robert Légaré, au sud partie par l'emplacement vendu à Louis Anderson et partie par celui de Monsieur Arthur Verret, sans bâtisse mais avec circonstances et dépendances.\" Pour être vendus au Bureau d'Enregistrement de Québec, le TREIZIÈME jour de JUIN prochain à DIX heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Dr J.R.GOBEIL.Québec, le 7 mai 1958.47746-19-2-0 [Première insertion: le 10 mai 1958] [Deuxième insertion: le 31 mai 1958] Fieri Faciae Québec, à savoir: (T \"-OFFICE DU CRÉDIT N° 87,980.< i-* AGRICOLE DU QUÊ-' BEC, corps politique et incorporé ayant son siège social à Québec, contre DAME MARIE BLANCHE GAUTHIER, épouse contractuellement séparée de biens de Théodore Robert, de Deschambault, comté de Portneuf, ledit Théodore Robert pour autoriser et assister son épouse.a) Le lot numéro treize (13) du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse de Deschambault.Sujet à une servitude pour ligne de tramission électrique en faveur de North Shore suivant acte enregistré sous le N° 76922.b) Le lot numéro quatorze (14) du cadastre officiel du comté de Portneuf, pour la paroisse de Deschambault.A distraire la partie vendue au Canadian Northern Quebec Ray., suivant acte enregistré sous le N° 48-977.A distraire la partie vendue à Nicholas Paquin suivant acte enregis- METTE, of Ste.Monique des Saules, widow of the late Eugène Tremblay, in his lifetime of the locality, and BERNADETTE TREMBLAY, fille majeure, making use of her rights, of Ste.Monique des Saules, jointly and severally.\"A piece of land measuring fifty-six feet (560 in front by seven feet (70 in depth to be taken and excluded from original lot number sixty-six of the subdivisions of original lot number ten (10-66 P.) of the official cadastre of the parish of Ancienne Lorette, county of Quebec, bounded northerly by the Renaud Road, today Masson Boulevard, southerly by the land hereinabove described and on the other, sides by Mr.Herménégilde Careau or representatives; with the houses and other buildings thereon erected, circumstances and dependences.\"An emplacement known and designated as forming part of lot number ten (P.10) of the official cadastre for the parish of Ancienne Lorette, county of Quebec, measuring eighty feet (800 in front, on the width by Renaud Street, today Masson Boulevard, with the same width at its depth line along one hundred and twenty-five feet (1250 of depth, english measure, bounded northerly by Renaud Street, today Masson Boulevard, southeasterly and westerly by Gaudiose Madore or representatives, all of which with buildings and dependencies.\"A piece of land known and designated as forming part of lot number eight hundred and twenty-four (P.824) of the official cadastre of St.Ambroise de la Jeune Lorette, measuring eighty-five feet and five inches (85' &\") wide in front along Valcartier Road, and one hundred feet (1000 w'de at the extreme point of the depth along five hundred and forty feet (5400 of depth, english measure, bounded in front, southwesterly, by Valcartier Road, in the rear northeasterly by the land of Arthur Verret, northerly by the land of Robert Légaré, southerly partly by the emplacement sold to Louis Anderson and partly by that of Mr.Arthur Verret, without buildings but with circumstances and dependencies.\" To be sold at the Registry Office of Quebec, the THIRTEENTH day of JUNE next at TEN o'clock in the forenoon.Dr.J.R.GOBEIL, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, May 7, 1958.47746-19-2 [First insertion: May 10, 1958] [Second insertion: May 31, 1958] Fieri Facias Quebec, to wit: ( /QUEBEC FARM CREDIT No.87,980. TREAULT, de la 4>a-Iroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, veuve de feu LUCIEN SAINT-PIERRE, en son vivant cultivateur de Saint=Pie-de-Bagot, district de Saint-Hyacinthe, demanderesse vs LAURENT SAINT-PIËRRE, ci-devant de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, et actuellement domicilié à Pointe-Gatincau, district de Hull, défendeur, Saisis comme appartenant audit défendeur: A) Un emplacement situé au sud de la rivière Yamaska, côté sud du chemin public, en la paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, connu et désigné au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, comme étant partie du lot quatre-vingt-seize (P.96) de forme irrégulière, et dont le contour est ainsi déterminé: Partant d'un point situé sur le chemin public, à une distance de 66 pds, de la ligne de division séparant le terrain présentement décrit «le celui ci-après décrit en second lieu, ladite ligne se dirigeant vers le nord sur la distance de 66 pds le long du chemin public, jus-u'à la ligne de division du terrain présentement écrit de celui ci-après décrit, qui appartenait à M.Dufresne; de ce point formant un angle et se dirigeant vers l'est en suivant ladite ligne de division sur une longueur de 334 pds; de ce point formant un angle droit et se dirigeant vers le sud sur une distance de 90 pds; de ce point formant im nouvel angle droit et se dirigeant vers l'ouest sur une distance de 307 pds.et de ce point formant un angle et se dirigeant sur une distance de 69 pds en ligne droite de manière a aller rejoindre le point de départ à l'extrémité ouest de la ligne de front du terrain présentement décrit; lequel emplacement tient en front au chemin public, en profondeur et d'un côté par le résidu du lot numéro 96 restant la propriété de way, going towards the north, measured in the eastern line or lateral line, l>etween the two lots bearing the same number 116, one of which is now presently occupied by Leopold Charbonneau, and the other by Lorenzo Charbonneau, without titles, also at a distance of 1770 feet, starting from the north side of the fence of the Montreal-Sherbroo-ke highway, going towards the north measured in the western line of the said lot or lateral line between lots 115 and 116; the said bank being trapazoidal in form, measuring a length of 580 feet in the line between lots 115 and 116; a length of 345 feet in the fine between the two parts of lot No.116, and a width of 427 feet, forming a superficial area of 197,487 square feet or 5.37 square arpents; the whole according to plan by the Roads Department dated July 20, 1932.With active or passive, apparent or unapparent servitudes.3.A plot of land of 21 arpents and 80 rods in superficial area, without guarantee of measure, known as being lot number 500 on the cadastre of the parish of Saint-Paul d'Abbotsford.Without building.To he sold at the door of the parochial church of Saint-Paid d'Abbotsford, in the county of Rouville on the TWELFTH day of JUNE 1958, at TEN THIRTY o'clock in the forenoon.RICHARD BOUSQUET, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Saint-Hyacinthe, May the 6th, 1958.47748-19-2-o Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Saint-Hyacinthe Superior Court, / T\\AME ÊMILIENNE TÉ-No.10065.< Y TREAULT, of the Pa-Irish of Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, District of Saint-Hyacinthe, widow of the late LUCIEN SAINT-PIERRE, in his lifetime, farmer of Saint-Pie-de-Bagot.District of Saint-Hyacinthe; plaintiff vs LAURENT SAINT-PIERRE, formerly of the parish of Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, district of Saint-Hyacinthe, and presently domiciled at Gatineau Point, district of Hull, defendant.Seized as belonging to suid defendant: A) An emplacement situated south of the Yamaska River, on the south side of the public highway, in the parish of Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, known and designated on the official cadastre of the parish of Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, as being part of lot ninety-six (J*.90) of irregular shape, the circumference of which is as follows: commencing at a point situate on the public highway, at a distance of 06 ft.from the dividing line between the land presently described and that hereinafter described secondly, the said line in a northerly direction along a distance of 66 feet, along the public highway, as far as the dividing line of the land presently described and that hereinafter described, belonging to Mr.Dufresne; from this point forming an angle and in an easterly direction along the said dividing line along a length of 334 feet; thence forming a right angle, in a southerly direction, along a distance of 90 feet; thence forming another right angle and in a westerly «Krection along a distance of 307 feet, and from this point forming an angle, along a distance of 69 feet in a straight line in order to join the point of commencement at the westerly extremity of the front line of the land presently .described; which emplacement is adjacent in front, to the public highway, in depth and on one side to the residue of lot number 96 remaining 3 1770 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1958, Tome 90, N° 19 P.Péloquin ou représentants, et de l'autre côté the property of P.Péloquin or representatives, £ar le terrain en second lieu décrit ci-après, and on the other side, to the land described e tout à la mesure anglaise.hereinafter in the second place.All of which in English measure.Avec maison et autres bâtisses dessus érigées.With house and other buildings thereon erected.Avec et sujet aux droits de passage tel qu'éta- With and subject to rights-of-way as esta-blis aux titres de propriété du vendeur, enre- blished in the Vendor's titles of ownership, registres à St-Hyacihthe au numéro B-79503 et gistered at St.Hyacinthe as number B-79503 décrits comme suit: and described as follows: Droit de passage à Pierre Péloquin ou repré- Right-of-way in favour of Pierre Péloquin or sentants, ainsi qu'au propriétaire du terrain representatives, as well as the owner of the vendu présentement dans un chemin pour com- land presently sold to a road in order to reach muniquer au chemin public, l'entretien de ce the public highway, the cost of maintenance of min devant être à frais commun, et tel chemin this road to be assumed jointly, and said road ne pouvant pas être déplacé de l'endroit où il not to be moved from the place where it is est présentement établi.presently located.Droit de passage à l'acquéreur ou représen- Right-of-way in favour of the purchaser or tants, à perpétuité à pieds ou en voiture, pour representatives, in perpetuity, on foot or driving, communiquer au chemin ci-dessus décrit, fai- in order to communicate with the road described sant partie du même lot numéro 96 dudit cadas- hereinabove, forming part of the same lot numb-tre, et ce sur le terrain de Pierre Péloquin ou er 96 of said cadastre, and such, on the land of représentants, en faveur du terrain présente» Pierre Péloquin or representatives, in favour of ment vendu.the land presently sold.Droit de passage en faveur de Pierre Péloquin Right-of-way in favour of Pierre Péloquin or ou représentants sur le terrain présentement representatives on the land presently sold, in vendu, pour communiquer du terrain de ce order to commute between the land of the latter dernier au chemin public, à perpétuité, à pieds and the public highway, in perpetuity, on foot ou en voiture, tel terrain étant partie du même or driving, which land* being part of the same lot numéro 96 dudit cadastre; lot number 96 of said cadastre; Droit de passage en faveur du terrain présen- Right-of-way attached to the land presently tement vendu sur le terrain «le Pierre Péloquin sold, on the land of Pierre Péloquin or represcn-ou représentants, sur partie du même lot numéro tatives, on part of same lot numlier 96, in order 96, pour communiquer du chemin public à la to commute from the public highway to the rivière Yamaska, à perpétuité, en toutes saisons Yamaska River, in perpetuity, in all seasons of de l'année.the year.B) Un autre emplacement situé au même lieu, B) Another emplacement situate in the same de 90 pds de largeur, par 285 pds de profondeurs, locality, 90 feet wide, by 285 feet deep, English mesure anglaise, à prendre dans la partie sud- measure, to be taken from the southwesterly ouest de la terre se trouvant du côté sud du part of the farm situate on the southerly side chemin public, et faisant partie du lot quatre- of the public highway, and forming part of lot vingt-dix-sept (Partie 97) du cadastre officiel ninety-seven (P.97) of the official cadastre of de la paroisse de Notre-Dame de Saint Hyacin- the parish of Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, the; avec les bâtisses dessus érigées, et borné with buildings thereon erected, and bounded as comme suit: en front, par le chemin public, du follows: in front, by the public highway, on the côté sud-ouest par P.Péloquin ou représentants, southwesterly side by P.Péloquin or represen-des côtés sud-est et nord-est par le résidu dudit tatives, on the southeasterly and northeasterly lot numéro 97 du même cadastre.sides by the residue of said lot number 97 of the same cadastre.* Pour être vendus à la porte de l'église parois- To be sold at the door of the parochial church siale du Précieux-Sang de La Providence, comté of Précieux-Sang de La Providence, county of de Saint-Hyacinthe, le ONZIÈME jour de JUIN Saint-Hyacinthe, the ELEVENTH day of 1958, à DIX heures et DEMIE a.m.JUNE, 1958, at TEN-THIRTY o'clock a.m.Le Shérif, R> BOUSQUET, Bureau du Shérif, R* BOUSQUET.Sheriff's Office, Sheriff.Saint-Hyacinthe, le 6 mai 1958.47751-19-2-o Saint-Hyacinthe, May 6, 1958.47751-19-2 Fieri Facias de Bonis et de Terris Fieri Facias de Bonis et de Terris District de Saint-Hyacinthe - District of Saint-Hyacinthe Cour Supérieure, / PHILIPPE MARCIL, et Superior Court, / \"PHILIPPE MARCIL and N° 10-535.-J A SYLVIO VALCOURT, No.10-535.< * SYLVIO VALCOURT.I tous deux marchands de grain, 'both merchants of Saint-Li- de Saint-Liboire, comté de Bagot, district de boire, county of Bagot, district of Saint-Hyacin- Saint-Hyacinthe, demandeurs, vs LES HÉRI- the, plaintiffs; vs THE HEIRS OF THE LATE TIERS DE FEU ZOLTAN SIMON, en son ZOLTAN SIMON, in his lifetime, a farmer, of vivant, cultivateur, de Saint-Liboire, comté de Saint-Liboire, county of Bagot.district of Saint- Bagot, district de Saint-Hyacinthe; défendeurs Hyacinthe: defendants.Saisies comme appartenant audits défendeurs: Seized as belonging to said defendants: 1° Une terre située sur le rang Saint-Edouard, 1.A farm situated in range Saint-Edouard, en la paroisse de Saint-Liboire, de la contenance in the parish of Saint-Liboire, containing four de quatre arpents de largeur sur vingt et un arpents in width by twenty-one arpents in depth, arpents de profondeur, plus ou moins, étant le more or less, being lot number one hundred and lot numéro cent soixante du cadastre officiel sixty of the official cadastre of the parish of de la paroisse de Saint-Liboire; avec bâtisses y Saint-Liboire; with buildings thereon erected, érigées. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 A distraire dudit lot: a) la partie dudit lot vendue à la corporation municipale de la paroisse de Saint-Liboire, pour élargissement de la route, par contrat de vente reçu devant Mtre L.-A.Brunelle, notaire, le 29 mai 1921, enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Bagot sous le N° 56181 ; telle partie ayant une largeur de dix pieds sur la profondeur de la concession; b) la partie du même lot vendue à Sa Majesté le Roi pour le Gouvernement de la province de Québec, Ministère de la Voirie, pour élargissement de chemin, par contrat reçu devant Mtre André Dumont, notaire, le 18 avril 1949, enregistré au bureau d'enregistrement de Bagot sous le N° 86840, telle partie ayant une superficie de cinq mille trois cents pieds carrés, mesure anglaise, ou cent quarante-quatre millième d'arpent carré.Le vendeur réserve les droits de The Bell Telephone Co.of Canada sur ledit lot, pour construction et entretien de lignes de téléphone, suivant actes à cette fin enregistrés à Bagot sous les numéros 56153 et 70760.2° Un terrain situé sur le rang Saint-Patrick, en la paroisse de Saint-Liboire, faisant partie du lot trois cent dix (P.310) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Liboire, d'un arpent de largeur sur la profondeur qu'il y a à partir du chemin de front dudit rang jusqu'au chemin de fer du Canadien National, moins une lisière de terre d'environ quarante pieds de largeur le long du chemin de fer, tel terrain borné en front au chemin dudit rang, en profondeur par le terrain du Canadien National, d'un côté aux terrains de Raoul Chabot et Louis Plante, et de l'autre côté au terrain d'Alhéric Beauregard; avec bâtisses y érigées.3° Un terrain situé sur le rang Saint-Patrick, en la paroisse de Saint-Liboire, faisant partie du lot numéro trois cent onze (P.311) du cadas-.tre officiel de la paroisse de Saint-Liboire, d'un arpent de largeur sur la profondeur qu'il y a à partir du chemin de front dudit rang jusqu'au chemin de fer du Canadien National, borné d'un côté par le terrain d'Albéric Beauregard, et de l'autre côté par le terrain d'Adrien Dion; avec bâtisses y érigées.lie vendeur réserve, en faveur de qui il appartiendra, la servitude de chemin à la profondeur du terrain faisant partie du lot N° 311, le long du chemin de fer, chemin de quarante pieds de largeur, pour l'utilité du public, dans le cas où tel chemin serait ouvert jusqu'au chemin du rang Saint-Edouard; Le vendeur déclare que lesdits terrains P.310 et P.311 sont affectés d'une servitude en faveur de Southern Canada Power Co.Ltd pour construction et entretien d'une ligne de transmission électrique, suivant acte à cet effet enregistré au bureau d'enregistrement de la divison de Bagot sous le numéro 84563.Pour être vendues à la porte de l'église paroissiale de Saint-Liboire, comté de Bagot, district de Saint-Hyacinthe, le QUATORZIÈME jour de JUIN 1958, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.BOUSQUET.Saint-Hyacinthe, le 6 mai 1958.47749-19-2-o To be excluded from said lot: a) that'part of said lot sold to the municipal' corporation of the parish of Saint-Liboire, for the widening of the road, by deed of sale passed before Mtre L.-A.Brunelle, notary, on May 29, 1921, registered in the Registry Office of the division of Bagot under No.56181; said part measuring ten feet wide by the depth of the concession; b) that part of the same lot sold to His Majesty the King for the Government of the Province of Quebec, Department of Roads, for the widening of the road, by contract passed before Mtre André Dumont, notary, April 18,1949, registered at the Registry Office of Bagot under number 86840, said part having an area of five thousand three hundred square feet, English measure, or one hundred and forty-four thousandths of a square arpent.The vendor reserves all the rights of The Bell Telephone Co.of Canada on said lot, for the building and maintenance of telephone lines, according to deeds, for said purpose, registered at Bagot under numbers 56153 and 70760.2.A piece of land situated in range Saint-Patrick, in the parish of Saint-Liboire, forming part of lot three hundred and ten (P.310) of the official cadastre of the parish of Saint-Liboire, one arpent in width by the depth that exists as from the front road of said range as far as the Canadian National Railroad, save a strip of land of some forty feet in width along the railroad, which land is bounded in front by the road of said range, in depth by the land of the Canadian National Railway, on one side by the land of Raoul Chabot and Louis Plante, and on the other side by the land of Albéric Beauregard; with buildings thereon erected.3.A piece of land situated in range Saint-Patrick, in the parish of Saint-Liboire, forming part of lot number three hundred and eleven (P.311) of the official cadastre of the parish of Saint-Liboire, of one arpent in width by the depth which exists as from the front road of said range as far as the Canadian National Railway, bounded on one side by the land of Albéric Beauregard, and on the other side by the land of Adrien Dion, with buildings thereon erected.The vendor reserves, in favour of whoever the owner may be, the road servitude at the depth of the land forming part of lot N.311, along the railroad, a road ot forty feet wide, for public purposes, in which case said road would be opened as far as the road of range Saint-Edouard; The vendor declares that the said pieces of land P.310 and P.311 are boundened with a servitude in favour of Southern Canada Power Co.Ltd for the building and maintenance of an electric transmission line, according to a deed to this effect registered at the Registry Office of the division of Bagot under number 84653.To be sold at the door of the parochial church of Saint-Liboire, county of Bagot, district of Saint-Hyacinthe, the FOURTEENTH day of JUNE, 1958, at TEN THIRTY o'clock in the forenoon.R.BOUSQUET, Sheriff's Office, Sheriff.Saint-Hyacinthe, May 6,1958.47749-19-2-o 1772 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 10 mai 1968, Tome 90, N° 19 TERREBONNE Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure, N° 26134.jJTORACE BOILEAU, \u2022 ** comptable agréé, des cité et district de Montréal, et HERVÉ FOURNIER, tailleur, de Lachute, district de.Terrebonne, tous deux en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de la succession de feu Adolphe Raymond, en son vivant de Lachute, demandeurs es-qualité; vs DAME ISABELLE CYR, veuve non remariée de Louis Albert Pharand, en son vivant de Lachute, district de Terrebonne, ladite Dame Isabelle Cyr, en sa qualité d'exécutrice testamentaire des biens de la succession de feu Louis Albert Pharand, cette dernière demeurant à Buckingham, district de Hull, et LES HÉRITIERS DE LA SUCCESSION DE FEU LOUIS PHILIPPE PHARAND, en son vivant, de Lachute, district de Terrebonne, défendeurs; et LE RÉGISTRATEUR DE LA DIVISION D'EMREGISTREM ENT POUR LE COMTÉ D'ARGENTEUIL, mis-en-cause.AVIS DE VENTE \u20141° Un certain emplacement situé en la ville de Lachute, sur le côté nord de la Grand'rue, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jérusalem d'Argen-teuil, comme étant la moitié est du lot sept cent soixante-six (P.14 E.766) avec les bâtisses dessus; borné au nord par une ruelle, connue sous le numéro cadastral 865, au sud par la Grand'rue, à l'est.par le lot N° 754 et à l'ouest par la moitié ouest dudit lot 766, appartenant à L.L.Legault ou ses représentants; 2° Une certaine lisière de terrain située au même endroit, et faisant partie du lot numéro sept cent cinquante-quatre (P.754) mesurant six pouces de large sur soixante-dix-huit pieds de profond borné en front au sud par la Grand'rue, en arrière au nord et d'un côté à l'est par le résidu dudit terrain appartenant aux représentants légaux de feu Gédéon Desjardins, et à l'ouest par ladite partie du lot 766 ci-dessus décrite; ladite lisière supporte une partie de l'édifice érigée sur ladite partie du lot 766.Pour être vendu à la porte de l'église catholique Ste-Ai astasie .'e Lachute, MERCREDI, le VINGT-HUITIÈME jour de MAI 1958 à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Conditions: argent comptant.Le Shérif, Daté à St-Jérôme, GEO.AUCLAIR.ce 14 avril 1958.47569-16-2-o TERREBONNE Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, ) XJORACE BOILEAU, No.26134.>11 chartered accountant, of ; the city and district of Montreal, and HERVÉ FOURNIER, tailor, of Lachute, district of Terrebonne, both in their quality of testamentary executors of the estate of the late Adolphe Raymond, in his lifetime of Lachute, plaintiffs, es-qualité; vs DAME ISABELLE CYR, unremarried widow of Louis Albert Pharand, in her lifetime of Lachute, district of Terrebonne, the said Dame Isabelle Cyr, in her quality of testàmertary executrix of the property of the estate of the late Louis Albert Pharand, the latter residing at Buckingham, district of Hull, and THE HEIRS OF THE ESTATE OF THE LATE LOUIS PHILIPPE PHARAND, in his lifetime, of Lachute, district of Terrebonne, defendants; and THE REGISTRAR OF THE REGISTRY DIVISION FOR THE COUNTY OF ARGENTEUIX, mis-en-cause.NOTICE OF SALE 1.A certain emplacement situated in the town of Lachute on the north side of the Grand' rue, known and designated on the official plan and in the book of reference for the parish of St.Jérusalem d'Argenteuil, as being the eastern half of lot seven bundled and sixty-six (P.E.14 766) with the buildings thereon erected; bounded on the north by a lane, known under the cadastral number 865, on the south, by the Grand'rue, on the east, by lot No.754 and on the west, by the western half of the said lot 766, belonging to L.L.Legault or his representatives; 2.A certain strip of land situated in the same place, and forming part of lot number seven hundred and fifty-four (P.754) measuring six inches in width by seventy-eight feet in depth, bounded in front on the south by the Grand'rue, in rear on the north and on one side on the east, by the residue of the said lot of land, belonging to the legal representatives of the late Gédéon Desjardins, and on the west, by the said part of lot 766 hereabove described; the said strip of land supports a part of the edifice erected on the said part of lot 766.To be sold at the catholic church door of Ste.Anastasie de Lachute, WEDNESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of MAY, 1958, at HALF-PAST TEN o'clock in the forenoon.Conditions: Cash.GEO.AUCLAIR, Dated at St.Jérôme, Sheriff, this 14th day of April.1958.47569-16-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N° 19 Action en separation de biens: Lecours vs Turgeon.1722 Arrêtes en Conseil: S 387 \u2014 Barbier-coiffeurs, région de Hull.1723 436 \u2014 Preuves photographique de certains documents (Hampstead).1722 436 \u2014 Preuves photographique de certains documents (Hull).1723 Index of the Quebec Official Gazette, No.19 Action for Separation as to Property: Lecours vs Turgeon.1722 Orders in Council: 387 \u2014 Barbers and hairdressers, région of Hull.1723 436 \u2014 Photographic proof of certain documents (Hampstead).- 1722 436 \u2014 Photographic proof of certain documents (Hull).1723 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1773 Avis aux intéresses: 1695 Notice to Interested Parties: 1695 Avis divers: Arthur Blouin Limitée (Directeurs)____ Corporation de Gaz Naturel du Québec (Nouveaux tarifs).Drainage Ste-Marie Inc.-?Ste Marie Drainage Inc.(Directeurs).Greenland Realties Ltd (Directeurs).La Caisse des Jeunes Travailleurs de Lachute (Fondation).La Compagnie Canadienne du Théâtre Club Ltée (Directeurs).L'Association Sportive de la Rive Nord (Règlements).Les Entreprises Ste-Marie Inc.\u2014 Ste Marie Enterprises Inc.(Directeurs).Midgal Construction Ltd (Directeurs).Occupational Therapy & Rehabilitation Centre (Règlement).Saint-Martin, ville (Règlement No 67).Super Service Fowarding Ltd (Directeurs).Syndicat Coopératif des Producteurs de Bleuets de St-Eugène d'Argentenay (Fondation).Syndics de la paroisse de Saint-Jérôme de Lac Saint-Jean (Rachat d'obligations) .Chartes \u2014 Abandon de: Best's Ladies Wear Inc.L.V.Textiles Limited.: The American Advertising Agency Limited .The Page Fence and Wire Products Company, Limited.Compagnies dissoutes: Breakeyville Stores Co.Ltd.Corporate Services Inc.Four Grand Investments Ltd.Giroux Motor Sales Ltd.Hibbard Motors Ltd.L'Édifice Chevalier Ltée.Notre Maison (Compagnie Ltée) Simard Chevalier & Choyer Limitée.Western Taxi Association Ltd.DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Boucherville.Chicoutimi Nord, ville.Clapham.Huberdeau.Lawrenceville, village.- Ste-Anne-la-Pérade, village Ste-Marie Madeleine.St-Philippe-de-Phillipsburg.Ville-Marie.Ville-Marie.Mines: Révocation de la vente de terrains miniers dans le canton de Beauchastel.Terres et Forêts: Service du Cadastre: Charlesbourg, paroisse.Montréal, cité (Quartier St-Antoine).Montréal, cité (Quartier St-Antoine).Ste-Foye, paroisse.Miscellaneous Notices: 1728 Arthur Blouin Limitée (Directors).1728 Quebec Natural Gas Corporation (New 1727 rates).1727 Drainage Ste-Marie Inc.\u2014 Ste Marie 1731 Drainage Inc.(Directors).1731 1731 Greenland Realties Ltd.(Directors).1731 La Caisse des Jeunes Travailleurs de 1729 Lachute (Foundation).1729 The Canadien Company of Theatre 1728 Club Ltd.(Directors).1728 L'Association Sportive de la Rive Nord 1727 (By-laws).1727 Les Entreprises Ste Marie Inc.\u2014 Ste 1731 Marie Enterprises Inc.(Directors).1731 1728 Midgal Construction Ltd (Directors).1728 Occupational Therapy & Rehabilita- 1729 tion Centre (By-law).1729 1730 Saint-Martin, town (By-law No.67).1730 Super Service Fowarding Ltd (Direc- 1738 tors).1738 Syndicat Coopératif des Producteurs de Bleuets de St-Eugène d'Argente- 1730 nay (Foundation).1730 Trustees of the parish of Saint-Jérôme of Lake St.John (Redemption of 1729 bonds).1729 Charters \u2014Surrender of: 1732 Best's Ladies Wear Inc.1732 1732 L.V.Textiles Limited.1732 The American Advertising Agency Li-1732 mited.1732 The Page Fence and Wire Products 1732 Company, Limited.1732 1734 1732 1733 1733 1733 1733 1734 1734 1734 1736 1735 1735 1736 1735 1736 1735 1736 1735 1736 1736 1737 1738 1738 1737 Companies Dissolved: Breakeyville Stores Co.Ltd.1734 ' Corporate Services Inc.1732 Four Grand Investments Ltd.1733 Giroux Motor Sales Ltd.1733 Hibbard Motors Ltd.1733 L'Édifice Chevalier Ltée.1733 Notre Maison (Compagnie Ltée).1734 Simard Chevalier & Choyer Limitée.1734 Western Taxi Association Ltd.1734 DEPARTMENTAL NOTICES: Education: School Municipality of: Boucherville.1736 Chicoutimi Nord, town.1735 Clapham.1735 Huberdeau.s.1736 Lawrenceville, village.1735 Ste-Anne-la-Pérade, village.1736 Ste-Marie Madeleine.1735 St-Philippe-de-Phillipsburg.1736 \u2022 Ville-Marie.1735 Ville-Marie.1736 Mines: Cancellation of the sale of mining lands in the township of Beauchastel.1736 Lands and Forest: Cadastral Branch: Charlesbourg, parish.1737 Montreal, city (St.Antoine Ward) 1738 Montreal, city (St.Antoine Ward) 1738 Ste.Foye, parish.1737 1774 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 mai 1958, Tome 90, N° 19_ Lettres patentes: Agence d'Assurance Mercure Inc.\u2014 Mercure Assurance Agency Inc.1696 Amérivision Inc.1697 Argo Investments Inc.1697 Bersal Ltd.1697 Brompton Iron and Metal Inc.1698 Caligiuri Construction Company Limited.1698 Cartier Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Cartier.1698 Center Warehousing Ltd.1699 Château Country Club Inc.1699 Clanranald-Snowdon Corporation.1699 Clinique Médicale Ahuntsic Inc.1700 Collège de Matane.1744 Conrad Joyal Ltée.1700 Daily Realty Corp.1700 Dell Realties Ltd.1701 Delmar Heating & Supplies Company.1701 Dominion Air-Conditioning Company Limited.1701 École Centrale du Canada Inc.\u2014 Central School of Canada Inc.1702 Elgood Realties Ltd.1702 El-Lis Construction Co., Inc.1702 Évaporateur Portneuf Inc.1703 Family Hostess Sales Limited.1703 F.X.La Salle & Fils Inc.1703 Gaétan Gagné Incorporée.1704 Henry A.Cantin Incorporé.1704 Hershorn Investment Inc.1704 Hutchison Street Corporation.1705 Integral Development Inc.1705 Intercom of Montreal Inc.1705 Italian Motor Car Distributors Ltd.1706 J.Bernard Hamel, Inc.1706 J.Louis Voghel Ltée.1706 Labrador Cut Rate Food Market Inc.1707 La Cie d'Immeubles Dauville Ltée.1707 Lamondo Trading Corporation.1707 L'Association des Médecins Bactériologistes de la Province de Québec \u2014 Association of Medical Bacteriologists of the Province of Quebec.1708 Laurentide Graphite Corporation.1708 Laurentide Mineral Products Corporation.1708 Léo Paul Charbonneau Limitée.1709 Leran Copper Mining Company Limited 1709 Les Immeubles F.X.LaSalle & Fils Inc.1709 Loisirs Notre-Dame des Monts Inc.1710 Lord & Fils Inc.1710 L'Union des Jardiniers, Inc.1711 M.A.Blouin Inc.1711 Magasin Jat (Dolbeau) Ltée.1711 Magasin Lemieux Inc.1711 Maisonneuve Textiles Ltd.1712 Marcel Drouin Ltée \u2014 Ltd.1712 Marché Union Lie.1712 Mazel Corporation.1713 Montserrat Poultry Farms Inc.1713 Letters Patent: Agence d'Assurance Mercure Inc.\u2014.Mercure Assurance Agency Inc.1696 Amérivision Inc.1697 Argo Investments Inc.1697 Bersal Ltd.1697 Brompton Iron and Metal Inc.1698 Caligiuri Construction Company Limited.1698 Cartier Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Cartier.1698 \u2022Center Warehousing Ltd.1699 Château Country Club Inc.1699 Clanranald-Snowdon Corporation.1699 Clinique Médicale Ahuntsic Inc.1700 Collège de Matane.1744 Conrad Joyal Ltée.1700 Daily Realty Corp.1700 Dell Realties Ltd.1701 Delmar Heating & Supplies Company.1701 Dominion Air-Conditioning Company Limited.1701 École Centrale du Canada Inc.\u2014 Central School of Canada Inc.1702 Elgood Realties Ltd.1702 El-Lis Construction Co., Inc.1702 Évaporateur Portneuf Inc.1703 Family Hostess Sales Limited.1703 F.X.La Salle & Fils Inc.1703 Gaétan Gagné Incorporée.1704 Henry A.Cantin Incorporé.1704 Hecshorn Investment Inc.1704 Hutchison Street Corporation.1705 Integral Development Inc.1705 Intercom of Montreal Inc.1705 Italian Motor Car Distributors Ltd.1706 J.Bernard Hamel, Inc.1706 J.Louis Voghel Ltée.1706 Labrador Cut Rate Food Market Inc.1707 La Cie d'Immeubles Dauville Ltée.1707 Lamondo Trading Corporation.1707 L'Association des Médecins Bactériologistes de la Province de Québec \u2014 Association of Medical-Bacteriologists of the Province of Quebec.1708 Laurentide Graphite Corporation.1708 Laurentide Mineral Products Corporation.*.;.1708 Léo Paid Charbonneau Limitée.1709 Leran Copper Mining Company'Limited 1709 Les Immeubles F.X.LaSalle & Fils Inc.1709 Loisirs Notre-Dame des Monts Inc.1710 Lord & Fils Inc.1710 L'Union des Jardiniers, Inc.1711 M.A.Blouin Inc.1711 Magasin Jat (Dolbeau) Ltée.1711 Magasin Lemieux Inc.1711 Maisonneuve Textiles Ltd.1712 Marcel Drouin Ltée \u2014 Ltd.1712 Marché Union Inc.1712 Mazel Corporation.1713 Montserrat Poultry Farms Inc.1713 Travail: ' Labour: Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Food products retail trade, district of Alimentation au détail, région de Québec 1738 Quebec.;.1738 Convention collective relative à Fin- Collective agreement relative to the dustrie du fer et bronze d'ornemen- ornemental iron and bronze industry, tation, région de Montréal.1740 region of Montreal.1740 Examens du Barreau: Bar Examinations: St-François: pratique.1744 St.Francis: practice.1744 Trois-Rivières: examens.1744 Trois-Rivières: examination.1744 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 10th, 1968, Vol.90, No.19 1775 Nivel Realties, Inc.Old Rose Printing Co.Inc.Paradis Construction Ltd.\u2014 Paradis Construction Ltée.Pasoff Holdings Incorporated.P.E.Légaré Inc.Penrose Enterprises Ltd.Perma Investment Corporation.Provincial Hardwoods Inc.Restaurant Horizon Inc.Rock Lagacé & Co.Ltd.Roy Auto Parts Inc.Sheres Company Ltd.Sol Luncheonnettes Ltd.Spécialités Lucerne Specialties Inc.St Antoine Excavation Ltée.St.Leonard Realties, Inc.Terminal Packaging & Warehousing Company Inc.Villa Labelle Holdings Corp.W & D Transport Inc.Welwort Construction Ltd.William J.Segal & Sons Inc.Winer & Chazonoff Contractors Corp.Lettres patentes supplémentaires: Camp Hiawatha Inc.Les Fermes du Cap St-Jacques Ltée- L.J.Forget & Cie Ltée \u2014 L.J.Forget & Co.Ltd.Vanguard Explorations Limited.Ministère des Finances: Assurances: Alliance Compagnie d'Assurance-Vie.Fire Association of Philadelphia.Nomination: Divers.Office des marchés agricoles .du Québec: Avis de réception de plan conjoint de mise en marché: L'Association des producteurs de tabac jaune du Québec Inc.Le Syndicat Spécialisé des producteurs de bois de Rimouski (U.C.C.).Proclamations: Concernant l'abolition de certaines Cours de Magistrat.Concernant la tenue d'une élection partielle dans le district électoral de Matane.Sièges sociaux: Candiac Construction Ltd.' Caprive Oil and Gas Company Limited.Dadson Lake Chil>ougamau Mines Ltd.Les Placements Alvic Inc.Pennbec Mining Corporation.Soumissions: Beauport, ville, comm.scolaire (Correction) .Greenfield Park, ville.Matane, ville.t.Murdochville, comm.scolaire prot.Pincourt, village.Québec, cité.St-Hyacinthe, cité.1714 Nivel Realties, Inc.1714 1714 Old Rose Printing Co.Inc.1714 Paradis Construction Ltd.\u2014 Paradis 1714 Construction Ltée.1714 1715 Pasoff Holdings Incorporated.1715 1715 P.E.Légaré Inc.1715 1715 Penrose Enterprises Ltd.1715 1716 Perma Investment Corporation.1716 1716 Provincial Hardwoods Inc.1716 1716 Restaurant Horizon Inc.:.1716 1717 Rock Lagacé & Co.Ltd.1717 1717 Roy Auto Parts Inc.1717 1717 Sheres Company Ltd.1717 1718 Sol Luncheonnettes Ltd.1718 1718 Spécialités Lucerne Specialties Inc.1718 1718 St Antoine Excavation Ltée.1718 1719 St.Leonard Realties, Inc.1719 Terminal Packaging & Warehousing 1719 Company Inc.1719 1719 Villa Labelle Holdings Corp.1719 1720 W & D Transport Inc.1720 1720 Welwort Construction Ltd.1720 1720 William J.Segal & Sons Inc.1720 1721 Winer & Chazonoff Contractors Corp.1721 Supplementary Letters Patent: 1721 Camp Hiàwatha Inc.'.1721 1721 Les Fermes du Cap St-Jacques Ltée.1721 L.J.Forget & Cie Ltée \u2014 L.J.Forget 1721 & Co.Ltd.1721 1722 Vanguard Explorations Limited.1722 Department of Finance: Insurance: Alliance Mutual Life Insurance Com- 1745 pany.1745 1744 Fire Association of Philadelphia.1744 Appointment: 1745 Miscellaneous.1745 Quebec Agricultural Marketing Board: Notice of reception of joint marketing plan: L'Association des producteurs de tabac 1745 jaune du Québec Inc.1745 Le Syndicat Spécialisé des producteurs 1746 de bois de Rimouski (U.C.C.).1746 Proclamations: Concerning the abolishment of certain 1746 Magistrate's Courts.1746 Concerning the holding of a by-election 1748 in the electoral district of Matane.1748 Head Offices: 1749 Candiac Construction Ltd.1749 1750 Caprive Oil and Gas Company Limited.1750 1749 Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd.1749 1749 Les Placements Alvic Inc.1749 1749 Pennbec Mining Corporation.1749 Tenders: Beauport, town, school comm.(Cor- 1750 rection).1750 1753 Greenfield Park, town.1753 1754 Matane, town.1754 1752 Murdochville, prot.school com m.1752 1750 Pincourt, village.1750 1750 Quebec, city.1750 1755 St.Hyacinthe, city.1755 1776 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, QuêbecTW mai 1968, Tome 90, N° 19 Verras, Loi db faillite: Sales, Bankruptcy Act: Dufort, Wilfrid.1767 Dufort, Wilfrid.1757 Dumont, Roméo.1756 Dumont, Roméo.1756 Ventes par licitation: Sales by Licitation: Gauthier vs Gauthier et al.1757 Gauthier vs Gauthier et al.1757 Latham vs Latham et al.' 1758 Latham vs Latham rial.1758 Vente pour taxes: Sale fob Taxes: St-FeKcien, ville de.1759 St-Félicien, town of.1759 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Abitibi: ' Abitibi: Nadeau vs Brochu.1760 Nadeau vs Brochu.1760 Gaspé: Gaspé: Banque Toronto-Dominion vs Met hot.1760 Toronto-Dominion Bank vs Met hot_____ 1760 Fahey vs Lapointe.1761 Fahey vs Lapointe.1761 Moreau vs Moreau.1760 Moreau vs Moreau.1760 Hull: Hull: Murdoch vs Lanthier.1761 Murdoch vs Lanthier.1761 Iberville: Iberville: Boudreau vs Fafard.1762 Boudreau vs Fafard.1762.Joliette: Joliette: La Banque Provinciale du Canada vs The Provincial Bank of Canada vs O'Ryan.1762 O'Ryan.1762 Kamouraska: Kamouraska: Rioux vs Pelletier.1763 Rioux vs Pelletier.1763 Montreal: Montreal: Cie Henri Denis Ltée vs Chaffee.1763 Cie Henri Denis Ltée vs Chaffee.1763 Nicolet» Nicolet: L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Credit Bureau vs Cinq- vs Cinq-Mars.1763 Mars.1763 Québec: Quebec: Laurentides Automobiles Inc: vs Ver- Laurentides Automobiles Inc.vs Ver- mette.1764 mette.1764 L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Bureau Credit vs Gau- vs Gauthier et vir.1765 thier et vir.1765 Rimouski: Rimouski: Drapeau vs Ouellet.1767 Drapeau vs Ouellet.1767 La ville de Rimouski vs O.K.Chipcoré The town of Rimouski vs O.K.Chipcoré .Corporation Inc.1767 Corporation Inc.1767 Saint-François: St.Francis: L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Credit Bureau vs Bédard.1768 .vs Bédard.,.1768 Saint-Hyacinthe: Saint Hyacinthe: Marc i 1 et al vs Héritiers de Z o 1 tan Simon 1770 Mar ci 1 et al vs Heirs of Zoltan Simon.1770 Meunier vs Fleury.1768 Meunier vs Fleury.\u20141768 Tétreault vs Saint-Pierre.1769 Tétreault vs Saint-Pierre.1769 Terrebonne: Terrebonne: Boileau vs Héritiers de Ls-Ph.Pharand.1772 Boileau vs Heirs of Ls-Ph.Pharand.1772 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.