Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 février 1959, samedi 14 (no 7)
[" Tome 91, N° 7 726 Vol.91, No.7 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) s\".PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 14 février 1959 ii 1 i i AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter -la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, February 14th, 1950 i., ¦ ¦ NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwisèMhis last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes» Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 726 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces t Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifié que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502\u2014l-52-o Lettres patentes (P.G.13750-58) Aird Holding Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Dave G i Hick, fourreur, Irving Weiss, grossiste, Myer Malcoff et Sam Pinsky, marchands, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, amélioration et développement, sous le nom de \"Aird Holding Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958 L'Assistant procureur-général suppléant, 49851 P.FRENETTE.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise' the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, ' Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502\u2014l-52-o Letters Patent (A.G.13750-58) Aird Holding Ltd.Notice is hereby given hat under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Dave Gillick, Furrier, Irving Weiss, Wholesaler, Myer Malcoff and Sam.Pinsky, Merchants all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, improvement and development company, under the name of \"Aird Holding Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 200 common shares of $100 each and 800 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February ljih, 1969, Vol.91, No.7 727 P.G.13824-58) Airtha Associates Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation: David James McDougall, géologue conseil, de Pointe Claire, Alec Phelps Grigg, avocat, de Beaconsfield, James Auley McCuaig, ingénieur minier, Charles Ambrose Lane Hib-bard, avocat, et John Michael Grigg, comptable, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'entrepreneurs et conseillers en géologie, géophysique, métallurgie, chimie du sol et autres sciences de la terre et activités connexes, sous le nom de \"Airtha Associates Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 6,000 actions privilégiées et 2,000 actions ordinaires, toutes d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à West-mount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14406-58) Alpha Ferland Auto Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation: Alpha Ferland, garagiste, Edmond Ferland, rentier, et Pierre Fortin, avocat, tous de Bedford, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport; faire affaires comme garagistes et quincailliers, sous le nom de \"Alpha Ferland Auto Incorporée\", avec un capitol total de $60,000, divisé en 4,000 actions communes de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Bedford, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14607-58) Alpha Tool Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: David Litner, Seymour Machlovitch, tous deux avocats, et Rachel Souchereau, secrétaire, fille majeure, et usant de ses droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fondeurs en fer et manufacturiers de machinerie, outilleurs et métallurgistes, sous le nom de \"Alpha Tool Corporation\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.13824-58) Airtha Associates Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958, incorporating: David James McDougall, Consulting Geologist, of Pointe-Claire, Alec Phelps Grigg, advocate, of Beaconsfield, James Auley McCuaig, Mining Engineer, Charles - Ambrose Lane Hibbard, advocate, and John Michael Grigg, accountant, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors and consultants in geology, geophysics, metallurgy, soil chemistry and other earth sciences and allied fields, under the name of \"Airtha Associates Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 6,000 preferred shares and 2,000 common shares, all of a par value of $5 each.The head office of the company will be at West mount, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14406-58) Alpha Ferland Auto Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958, incorporating: Alpha Ferland, garage-keeper, Edmond Ferland, annuitant, and Pierre Fortin, advocate, all of Bedford, for the following purposes: To deal in automobiles and other means of transportation; to carry on business as garage-keepers and hardwaremen, under the name of \"Alpha Ferland Auto Incorporée\", with a total capital stock of $60,000, divided into 4,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Bedford, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14607-58) Alpha Tool Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: David Litner, Seymour Machlovitch, both advocates, and Rachel Souchereau, secretary, fille majeure et usant de ses droits, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as iron founders and manufacturers of machinery, tool makers and metal workers, under the name of \"Alpha Tool Corporation\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 1,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General. 728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tone 91, N°7 (P.G.14686-68) Artisanat Liturgique Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1958, constituant en corporation: Phil Cutler, Richard Dorais, tous deux avocats, et Huguette Lessard, sténographe,' célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'articles religieux, sous le nom de \"Artisanat Liturgique Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions communes de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.- Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.\u2022 Daté du bureau du Procureur général le treize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.13092-58) .A.Setlakwe Limited A.Setlakwe Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: James Walter, He m en s, de Pointe Claire, William Alston Campbell, de Montréal Ouest, William Desmond Thomas, de Beaconsfield, James Donald MacLean Brierley, de Westmount, tous quatre avocats, et Heather Leask Scott, secrétaire, fille majeure, de St-Lambert, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et fabricants de marchandises sèches, fourreurs, drapiers et bonnetiers, sous le nom de \"A.Setlakwe Limited \u2014 A.Setlakwe Limitée\", avec un capital total de $1,200,000, divisé en 2,400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 960,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Thetford-Mines, district judiciaire de Mégantic.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assis tant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14774-58) Auberge de la Montagne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dé la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert Dulude, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objtes suivants: Sous réserve des dispositions de la loi concernant ces matières, établir, entretenir et exploiter des hôtels, restaurants, auberges, boulangeries, tavernes, camps et maisons de touristes et stations estivales, sous le nom de \"Auberge de la Montagne Inc.\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale, et le montant avec lequel la compagnie commencera se 8 opérations sera d'au moins $500.Le siège social de la compagnie sera à Rout hier-ville, district judiciaire de Bonaventure.(A.G.14686-58) Artisanat Liturgique Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1958, incorporating: Phil Cutler, Richard Dorais, both advocates, and Huguette Lessard, stenographer, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in religious articles under the name of \"Artisanat Liturgique Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13092-58) A.Setlakwe Limited A.Setlakwe Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: James Walter Hemens, of Pointe Claire, William Alston Campbell, of Montreal West, William Desmond Thomas, of Beaconsfield, James Donald MacLean Brierley, of Westmount, all four advocates, and.Heather Leask Scott, secretary, spinster of the full age of majority, of St Lambert, for the following purposes: To cany on the businesses of dry goods merchants and manufacturers, furriers, clothiers and hosiers, under the name of \"A.Setlakwe Limited \u2014 A.Setlakwe Limitée\", with a total capital stock of $1,200,000, divided into 2,400 common shares of a par value of $100 each and 960,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Thetford-Mines, judicial district of Mégantic.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14774-58) Auberge de la Montagne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Dulude, of Dorion, and Robert-Y.Lanthier, of Ste.Rose, all advocates, for the following purposes: Subject to the provisions of the Act respecting the following; establish, maintain and operate hotels, restaurants, inns, bakeries, taverns, camps, tourist accommodation and summer resorts, under the name of \"Auberge de la Montagne Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value, and the amount with which the company shall commence its operations will be of a least $500.The head office of the company will be at RouthiervUIe, judicial district of Bonaventure. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 1959, Vol.9/, No: 7 729 Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14727-58) Avrum Investments Inc.Avis, est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation: Sydney Weisbord, comptable, Philip Borrow, notaire, et Jeanine Fobêrt, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Avrum Investments Inc.\",' avec un capital total de $40,000, divisé en 8,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4745 avenue Carlton, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14757-58) Barney Monieson Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date, du dix-huit décembre 1958, constituant en* corporation: Arthur I.Bronstein, William I.Miller, tous deux de Montréal, et Morton Bell, de St-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le négoce ou commerce général d'imprimeurs et photographes, sous le nom de \"Barney Monieson Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14740-58) Beauparc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Max Sidney Kaufman, avocat, de West-mount, Joseph Roy Hoffman, Oscar Respitz, avocats, Sydney Sederoff, étudiant en droit, et Muriel Frances Dyall, secrétaire, fille majeure, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et exploiter une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Beauparc Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions, catégorie \"A\", de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14727-58) Avrum Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958.incorporating: Sydney Weisbord, account, Philip Borrow, notary, and Jeanine Fobert, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Avrum Investments Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 8,000 shares of $5 each.The head office of the company will be at 4745 Carlton Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14757-58) Barney Monieson Inc.; Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Arthur I.Bronstein, William I.Miller, both of Montreal, and Morton Bell, of St.Laurent, all advocates, for the following purposes: To carry on the trade or business of general printers and photographers, under the name of \"Barney Monieson Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851k) Acting Deputy Attorney General.(A.G.14740-58) Beauparc Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Max Sidney Kaufman, advocate, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, Oscar Respitz, advocates, Sydney Sederoff, law student, and Muriel Frances Dyall, secretary, spinster of the full age of majority, all four of Montreal, for the following purposes: ^ .To acquire and exploit a certain immovable property, under the name of \"Beauparc Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 200 common shares of $100 each, 100 Class \"A\" shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. 780 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, U février 1969, Tome 91, N° 7 / (P.G.14755-58) Berko Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Ben Bercovitch, Saul Bercovitch, tous deux propriétaires de taxis, de Montréal, et Jon Kosorwich, avocat, de St-Laurent, pour les objets suivants: Exercée un commerce de taxis, sous le nom de \"Berko Enterprises Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4811 rue St-Urbain, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général.le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(PXL 14657-58) Berma Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: René Beaudry, de Verdun, Joseph Vallières et Louis-Claude Trudel, de Montréal, tous avocats, pour les objets, suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Berma Construction Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 100 actions communes de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.49851-o P.FRENETTE.(P.G.14075-58) Blackstone Building Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant' en corporation: Guy Girard, notaire, d'Outre m on t.Jeannine Picotte, veuve, secrétaire, et Lucien Pépin, notaire, de Montréal, pour les objets suivants:.Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs en construction, sous le nom de \"Blackstone Building Corporation\", avec un capital total de $75,000, divisé en 250 actions communes d'une valeur de $100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 55, Dela-vigne Road, Westmount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(A.G.14755-58) Berko Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Ben Bercovitch, Saul Bercovitch, both Taxi Proprietors, of Montreal, and Jon Kosorwich, advocate, of St.Laurent, for the following purposes: To carry on a taxicab business, under the name of \"Berko Enterprises Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 4811 St.- Urbain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14657-58) Berma Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: René Beaudry, of Verdun, Joseph Vallières and Louis-Claude Trudel, of Montreal, all advocates for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors; deal in real estate, under the name of \"Berma Construction Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 100 common shares of $100 each and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December, 1958.P.FRENETTE.49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14705-58) Blackstone Building Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Guy Girard, notary, of Outremont, Jeannine Picotte, widow, secretary, and Lucien Pépin, notary, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and building contractors under the name of \"Blackstone Building Corporation\", with a total capital stock of $75,000, divided into 250 common shares of à value of $100 each and into 500 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at 55 Delavigne Road, Westmount, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Wh, 1969, Vol.91, No.7 731 (P.G.14686-68) Boulangerie Mauricienne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1D58, constituant en corporation : Armand Bois vert, boulanger, de St-Mau-rice, Maurice Martel, avocat, et Lucille Roy, secrétaire, célibataire, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme boulangers et confiseurs, sous le nom de \"Boulangerie Mauricienne Inc.\", avec un capital total de 140,000, divisé en 4,000 actions communes d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Maurice, district judiciaire des Trqis-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14760-58) Brel Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Rollin G al lay, tous deux avocats, et Sarah Miller, sténographe, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles et de tous intérêts en iceux et des constructions ou autres bâtisses dessus érigées, limites à bois, pouvoirs hydrauliques et autres et propriétés immobilières et tous droits, titre ou intérêt sur lesdites propriétés, sous le nom de \"Brel Corporation\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14685-58) Boulangerie Mauricienne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1958, incorporating: Armand Boisvert, baker, of St.Maurice, Maurice Martel, advocate, and Lucille Roy, secretary, spinster, both of Montreal, for the following purposes: To carry on business as bakers and confectioners, under the name of \"Boulangerie Mauricienne Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the.company .will be at Saint-Maurice, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14760-58) Brel Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Rollin Gallay, both advocates, and Sarah Miller, stenographer, all of Montreal, for the following purposes: To deal with real estate or any interest therein, and buildings or other structures thereon erected, timber limits, water and other powers and immoveable property and any rights, title or interest in such property, under the name of \"Brel Corporation\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14659-58) Brookfield Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: John Maria Cerini, conseil en loi de la Reine, Paul-Denis Martel, tous deux de Montréal, et Robert Learmont Jamieson, de Pointe Claire, tous avocats, pour les objets suivants: k Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Brookfield Construction Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8255 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14659-58) Brookfield Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: John Maria Cerini, Queen's Counsel, Paul-Denis Martel, both of Montreal, and Robert Learmont Jamieson, of Pointe Claire, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Brookfield Construction Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at 8255 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE.49851 -o Acting Deputy Attorney General. 782 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, U février 1969, Tome 91, N° 7 (P.G.14653-68) Buffalo Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss et William Levitt, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Buffalo Construction Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté dû bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 ' P.FRENETTE.(P.G.14571-68) Byron Electric Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation: Edward H.Bernfeld, Jack B.Bob rove et Max Bernfeld, conseil en loi de la Reine, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'électricité et d'appareils électroniques, sous le nom de \"Byron Electric Corporation\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Lasalle, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14759-68) Camp Shop Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en cor- S,ration: Charles D.Grant, marcand, Beatrice rant, marchande, épouse séparée de biens dudit Charles D.Grant, tous deux de Montréal, et Manuel A.Mendell, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount, pour les objets suivants: Confectionner et exercer un commerce général d'articles vestimentaires et lingerie pour enfants, adolescents et dames ainsi que vêtements et mercerie pour hommes, sous le nom de \"Camp Shop Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.* .(A.G.14653-68) Buffalo Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Léo Rosentzveig, Stanley Taviss and William Levitt, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Buffalo Construction Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be e 1 Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney GeneriJ.this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14571-58) Byron Electric Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Edward H.Bernfeld, Jack B.Bobrove and Max Bernfeld, Queen's Counsel, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an electrical and electronics company, under the.name of \"Byron Electric Corporation\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at ville LaSalle, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14759-58) Camp Shop Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Charles D.Grant, merchant, Beatrice Grant, merchant, wife separate as to property of the said Charles D.Grant, both of Montreal, and Manuel A.Mendell, advocate and Queen's Counsel of Westmount, for the following purposes : To manufacture and generally deal in children's and teen-agers' and ladies' wearing apparel and lingerie, and men's clothing and haberdashery, under the name of \"Camp Shop Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February l#h, 1969, Vol.91, No.7 733 (P.G.13946-68) Candiac Services Limited Les Services Candiac Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958/ constituant en corporation: Arthur Dansereau, Claude Marchand, avocats, Raymond de Tremblay, étudiant, tous trois de Montréal, et Pierrette Demers, secrétaire, fille majeure, de St-Laurent, pour les objets suivants: Acheter, vendre ou autrement acquérir ou disposer, louer et exploiter des services de combustible, carburant et électricité, sous le nom de \"Candiac Services Limited \u2014 Les Services Candiac Limitée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14758-58) Cemp South Shore Shopping Plaza Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Godfroy Marin, avocat, de Pointe Claire, Yvonne Bélanger, Sylvia Vineberg, Dorothea Calver, secrétaires, filles majeures, et B.Robert Benson, étudiant en droit, tous les quatre de Montréal, pour les objets suivants: Construire, développer et exploiter des places marchandes, sous le nom de \"Cemp South Shore Shopping Plaza Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.13135-58) Centre de Ski de Matane Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Roger Desjardins, marchand, Jean Lebel, comptable agréé, et Georges-Alexandre Lebel, notaire, tous de Matane, pour les objets suivants: Exploiter un centre de ski, sous le nom- de \"Centre de Ski de Matane Incorporée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(A.G.13945-68) Candiac Services Limited Les Services Candiac Limitée Notice uThereby given that under Part I cl the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December 1958, incorporating: Arthur Dansereau, Claude Marchand, advocates, Raymond de Tremblay, student, all three of Montreal, and Pierrette Demers, secretary, fille majeure, of St.Laurent, for the following purposes: Buy, sell or otherwise buy or dispose of, rent and operate services re: fuel, motor fuel and electricity, under the name of \"Candiac Services Limited\u2014 Les Services Candiac Limitée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14758-58) Cemp South Shore Shopping Plaza Limited ' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, Yvonne Bélanger, Sylvia Vincberg, Dorothea Calver, secretaries, filles majeures, and B.Robert Benson, law student, all four of Montreal, for the following purposes: To construct, develop and operate shopping centres, under the name of \"Cemp South Shore Shopping Plaza Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 36,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13135-58) Centre de Ski de Matane Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Roger Desjardins, merchant, Jean Lebel, chartered accountant, and Georges-Alexandre Lebel, notary, all of Matane, for the following purposes: To operate a ski center under the name of \"Centre de Ski de Matane Incorporée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. 734 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 14 février 1969, Tome 91, N° 7 (P.G.14745-58) Certified Appraised Real Estate (Care), Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en cor- §oration: Ernest William Mockridgc, gérant, de t-Lambert, William Patrick Creagh, commis en loi, de ville Mont-Royal et Clifford George Meek, teneur de livres, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction, développement et placements, sous le nom de \"Certified Appraised Real Estate (Care), Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14028-58) Citrus Corporation of America (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date 'du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Richard Dale Weldon, de Pointe-Claire, Ross Trenholme Clarkson, John William Durn-ford, tous deux de ville Mont-Royal, Raymond Eric Parsons, de Wcstmount, at Charles Doherty Gonthier, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits alimentaires, sous le nom de \"Citrus Corporation of America (Canada) Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14539-58) Club de Curling Etchemin Inc.Etchemin Curling Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Henri Beaudry, de St-Romuald, Gaston Michaud et Gabrielle Vallée, de Québec, tous avocats, pour les objets suivants: Former un club sportif et promouvoir en particulier le jeu de curling, sous le nom de \"Club de Curling Etchemin Inc.\u2014 Etchemin Curling Club Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions communes de $50 chacune et en 400 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera rue St-Robert, Saint-Romuald, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(A.G.14745-58) Certified Appraised Real Estate (Care), Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, of St.Lambert, William Patrick Creagh, law clerk, of the town of Mount Royal, and Clifford George Meek, bookkeeper, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction, development and investment company, under the name of \"Certified Appraised Real Estate (Care), Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 shares of a par value of $10 each.The head office of the company will l>e at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G'.14028-58) Citrus Corporation of America (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Richard Dale Weldon, of Pointe-Claire, Ross Trenholme Clarkson, John William Durnford, l>oth of the town of Mount Royal, Raymond Eric Parsons, of Wcstmount, and Charles Doherty Gonthier, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in grocery products, under the name of \"Citrus Corporation of America (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14539-58) Club de Curling Etchemin Inc.Etchemin Curling Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Henri Beaudry, of St-Romuald, Gaston Michaud and Gabrielle Vallée, of Quebec, all advocates, for the following purposes: To form a sporting club and to promote, in particular, the game of Curling, under the name of \"Club de Curling Etchemin Inc.\u2014 Etchemin Curling Club Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $50 each and into 400 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at St-Robert Street, Saint-Romuald, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 735 (P.G.14831-58) Coastal Dredging Ltd.Avis esC donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Charles-Eugène Côté, boulanger, de Cap-Chat, Jean-Robert Deniers, ingénieur professionnel, de Montréal, et John Everett Keays, industriel, de Chandler, pour les objets suivants: Exercer, conduire et exploiter le commerce de draguage (Derdging), et faire la construction et la réparation de navires, dragues, chalands et de tout autre bâtiment flottant, sous le nom de \"Coastal Dredging Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la paroisse de Cap-Chat, district judiciaire de Gaspé.- Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14610-58) Commercial Photo Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Harry Blank, Conrad Shatner, avocats, et Albert Liddell, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un service de photos commerciales, sous le nom de \"Commercial Photo Service Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.# Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14711-58) Danalan Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation : Neil Phillips, avocat, Yvonne Bélanger et Sylvia Vineberg, secrétaire, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer des propriétés immobilières et immeubles aux fins de placements et agir comme bailleurs et administrateurs relativement à iceux, sous le nom de \"Danalan Investments Ltd.\", avec un capital total de $3,000, divisé en 300 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.12826-58) Delmar Investment Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.14831-58) Coastal Dredging Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Charles-Eugène Côté, baker, of Cap Chat, Jean-Robert Demers, professional engineer, of Montreal, and John Everett Keays, industrialist, of Chandler, for the following purposes: To carry on, conduct, and operate a dredging business, build and repair ships, dredges, barges and any other craft, under the name of \"Coastal Dredging Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be in the parish of Cap-Chat, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14610-58) Commercial Photo Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Harry Blank, Conrad Shatner, advocates, and Albert Liddell, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of commercial photo service, under the name of \"Commercial Photo Service Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14711-58) Danalan Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958, incorporating: Neil Phillips, advocate, Yvonne Bélanger and Sylvia Yinebcrg, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable property and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Danalan Investments Ltd.\", with a total capital stock of 83,000, divided into 300 shares of $10 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12826-58) Delmar Investment Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 736 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, lk février 1969, Tome 91, Nù 7 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en eate du deux décembre 1958, constituant en corporation: Jacques Lagassé, notaire, Mariasse h Smith et Antoine Tunnel, commerçants, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de prêteur d'argent, sous le nom de \"Delmar Investment Co.\", avec un capital total de $600,000, divisé en 600 actions communes de $100 chacune et en 5,400 actions privilégiées de $100 cahcune.Le siège social de la compagnie sera 86, rue Wellington, Nord, Appartement 2, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.13493-58) Delorme Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958.constituant en corporation: André Couture, Marcel Guy, notaires, et Roger Delorme, commerçant, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles, camions, moteurs, avions, canots-automobiles, appareils de radio, congélateurs et autres appareils électriques ou électroniques, bicyclettes et motocyclettes, sous le nom de \"Delorme Automobile Ltée\", avec un capital total de $50,000, divisé en 25,000 actions communes de $1 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14915-58) Détection Électronique du Feu Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Roger Létourneau, contrôleur, Lucie Paquet Létourneau, épouse contractuellcment séparée de biens dudit Roger Létourneau, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Armand Létourneau, comptable, tous de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'électricien, y compris celui d'appareils et accessoires électroniques, sous le nom de \"Détection Électronique du Feu Incorporée\", avec un capital total de $30,000, divisé en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 255, rue Dorchester, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date Uje second day of December, 1958, incorporating: Jacques Lagassé, notaire, Manasseh Smith and Antoine Tunnel, tradesmen, all of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on a general business as money-lender, under the name of \"Delmar Investment Co.\", with a total capital stock of $600,000, divided into 600 common shares of $100 each and into 5,400 preferred shares of $100 each.\u2022 The head office of the company will be at 86, Wellington Street, North, Apartment 2, Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13493-58) Delorme Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: André Couture, Marcel Guy, notaries, and Roger Delorme, dealer, all of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in automobiles, trucks, motors, airplanes, motor boats, radio sets, refrigerators and other electric and electronic apparatus, bicycles and motor cycles, under the name of \"Delorme Automobile Ltée\", with a total capital stock of $50,000, dividde into 25,000 common shares of $1 each and 1,000 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14915-58) Détection Électronique du Feu Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Roger Létourneau, comptroller, Lucie Paquet Létourneau, wife contractually separate as to property of the said Roger Létourneau, and duly authorized by him for these present purposes, and Armand Létourneau, accountant, all of Quebec, for the following purposes: To operate as an electrician, dealing also in electronic apparatus and accessories, under the name of \"Détection Électronique du Feu Incorporée\", with a total capital stock of $30,000, divided into 1,000 preferred shares of a par value of $10 each and into 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 255 Dorchester Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February lMh, 1969, Vol.91, No.7 737 (P.G.14808-68) Effex Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: Avram Harold Garmaise, comptable, Philip Borrow, notaire, et Jeanine-L.Fobert, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, et construction, sous le nom de \"Effex Investment Corp.\", avec un capital total de $10.000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1426 rue Clarke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14647-58) Émilien Frechette Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieu tenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Emilien Frechette, manufacturier, Irène Couture Frechette, ménagère, épouse contrac-tuellement séparée de biens audit Émilien Frechette, et Claude De Launière, comptable, tous de St-Emile, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de chaussures, sous le nom de \"Émilien Frechette Limitée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Emile, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14776-58) Errol Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Kalman Samuels, avocat, Stella Flader, avocat, du Barreau de la Colombie Britannique, épouse séparée de biens dudit Kalman Samuels, et Dan Goldberg, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: t Exploiter des postes de taxis, terrains de stationnement, stations de service et boutique de réparation pour véhicules et moteurs, sous le nom de \"Errol Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1434 ouest, rue Ste-Catherine, suite 203, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14808-58) Effex Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Avram Harold Garmaise, accountant, Philip Borrow, notary, and Jeanine-L.Fobert, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Effex Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1426 Clarke Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14647-58) Émilien Frechette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December 1958, incorporating: Émilien Frechette, manufacturer, Irène Couture Frechette, house-wife, wife contractually separate as to property of the said Emilien Frechette, and Claude De Launière, accountant, all of Ste.Emile, for the following purposes: To carry on the business of and deal in footwear, under the name of \"Emilien Frechette Limitée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each and 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Emile, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14776-68) Errol Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Kalman Samuels, advocate, Stella Flader, Lawyer of the Bar of British Columbia, wife separate as to property of the said Kalman Samuels, and Dan Goldberg, Shartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To operate taxicabs stands, parking lots, service stations and vehicle and motor repair shops, under the name of \"Errol Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1434 St.Catherine Street West, Suite 203, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. 738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1969, Tome 91,N°7 (P.G.14763-58) Eugène Hamelin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Eugène Hamelin, entrepreneur, Mme Alexina Leclerc, ménagère, épouse séparée de biens dudit Eugène Hamelin, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, René Bélanger, contremaître, et Emmanuel Massé, comptable, tous de Granby, pour les objtes suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Eugène Hamelin Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 300 actions communes de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE: (P.G.14609-58) Everyman's Bookshop Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première 'partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Maurice Joseph Boxer, Bernard Mcrgler, avocats, et Sarah Miller, secrétaire, fille majeure et en pleine possession de ses droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une boutique de livres, sous le nom de \"Everyman's Bookshop Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1C0 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14746-58) Exposition du Meuble Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Paul Gagnon, Henri Beaupré, avocats, et Yvette-R.Gagnon, ménagère, épouse séparée de biens dudit Paul Gagnon, tous de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles et de nouveautés, sous le nom de \"Exposition du Meuble Inc.\", avec un capital total de $50,-000, divisé en 3,000 actions communes de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1285, boulevard Charest, ouest, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o - P.FRENETTE.(A.G.14763-58)v Eugène Hamelin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Eugène Hamelin, contractor, Mrs.Alexina Leclerc, housewife, wife separate as to property of the said Eugène Hamelin, and duly authorized by him for these present purposes, René Bélanger, foreman, and Emmanuel Massé, accountant, all of Granby, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors; to operate a business dealing in immoveables, -under the name of \"Eugène Hamelin Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 300 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14609-58) Everyman's Bookshop Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing .date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Maurice Joseph Boxer, Bernard Mergler, advocates, and Sarah Miller, secretary, spinster in full exercise of her rights, all of Montreal, for the following purposes: To operate a bookshop business, under the name of \"Everyman's Bookshop Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14746-58) Exposition du Meuble Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Paul Gagnon, Henri Beaupré, advocates, and Yvette-R.Gagnon, housewife, wife separate as to property of the said Paul Gagnon, all of Quebec, for the following purposes: To operate and industry and business dealing in furniture and in novelties, under the name of \"Exposition du Meuble Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1285 Charest Boulevard, West, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 739 (P.G.14664-58) Faculty Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dé Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation : Leonard Liverman, Julius Briskin, Arthur Yanofsky, avocats, et Max Sbrier, commis, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains et amélioration, sous le nom de \"Faculty Investment Inc.\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de là compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant,.49581 P.FRENETTEr (P.G.14698-58) Fairland Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation : Eddy Bergeron, employé de bureau, Rodolphe Gariépy, avocat, et Madeleine Soumis, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Fairland Limited\", avec un capital total de $250,000, divisé en 10,000 actions communes de $10 chacune et en 1,500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1290, rue Saint-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14562-58) Falcon Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous le nom de \"Falcon Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à.9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14664-58) Faculty Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Leonard Liverman, Julius Briskin, Arthur Yanofsky, advocates, and Max Shrier, clerk, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land and improvement company, under the name of \"Faculty Investment Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each and 1,000 common snares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14698-58) Fairland Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Eddy Bergeron, office employee, Rodolphe Gariépy, advocate, and Madeleine Soumis, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on as builders and as general building contractors; to operate a business dealing in real estate, under the name of \"Fairland Limited\", with a total capital stock of $250,000, divided into 10,000 common shares of $10 each, and into 1,500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1290 Saint-Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14562-58) Falcon Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, advocates, and Nicole Paternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and development company, under the name of \"Falcon Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be, at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General. 740 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Ufêwrier 1969, Tome 91, N° 7 (P.G.13970-68) v Ferronnerie Leveillé Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1968, constituant en corporation: Joseph-Elisée Leveillé, commerçant, Guy Leveillé, comptable, et Gérard-F.Lapointe, comptable agréé, tous de Rivière-du-Loup, pour les objets suivants: Faire affaires comme quincailliers et entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom de \"Ferronnerie Leveillé Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 400 actions communes de $100 chacune et en 600 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14611-68) F.J.Guns ton Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1968, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, avocat et conseil en loi de la Reine, Benjamin J.Greenberg, étudiant, et Mary Watt, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger un commerce à forfait, à commission et celui d'une agence en général; exercer le commerce de distributeurs, agents de manufacturiers et marchands à commission de couvertures de planches à repasser, housses de planches à repasser et de matelas, bourrures dè coton et autres marchandises de même nature, sous le nom de \"F.J.Gunston Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49861 P.FRENETTE.(P.G.13534-58) Foyer d'Accueil Domremy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Edmond Casai ion, de Shawinigan, Wilbrod L'Heureux, du Cap-de-la-Madeleine, tous deux contremaîtres, et Léo Lafrenière, propagandiste, des Trois-Rivières, pour les objets suivants: L'entraide aux alcooliques; la réhabilitation, le traitement physique et mental et le logement des alcooliques, sous le nom de \"Foyer d'Accueil Domremy Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $100,000.(A.G.13970-58) Ferronnerie Leveillé Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Joseph-Elisée Leveillé, dealer, Guy Leveillé, accountant, and Gérard-F.Lapointe, chartered accountant, all of Rivière-du-Loup, for the following purposes: To carry on business as hardwaremen and contractors in plumbing, heating and refrigeration, under the name of \"Ferronnerie Leveillé Ltée\", with a total capital stock of $100,000, didived into 400 common shares of $100 each and 600 preferred shares of $100 each.The head office of the' company will be at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14611-58) F.J.Gunston Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, Benjamin J.Greenberg, student, and Mary Watt, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To establish, maintain and conduct a jobbing, commission and general agency business; and carry on the business of distributors, manufacturers agents and commission merchants in ironing board pads, ironing board covers, mattress pads, cotton pads and other merchandise of similar nature, under the name of \"F.J.Gunston Corporation\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and: 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958._ P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13534-58) Foyer d'Accueil Domremy Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Edmond Casabon, of Shawinigan, Wilbrod L'Heureux, of Cap-de-la-Madeleine, both foremen, and Léo Lafrenière, propagandist, of Trois-Rivières, for the following purposes: Mutual.aid for alcoholics; rehabilitation, physical and mental treatment and housing of alcoholics, under the name of \"Foyer d'Accueil Domremy Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 741 Le siège social de la corporation sera 884, Haut-boc, Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.- Daté du bureau dp Procureur général, le seize décembre^SS.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14816-58) F.X.Lnmontngne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Laurent Lamontagne, entrepreneur, Gérard Sylvain, comptable, et Mlle Monique Lamontagne, ménagère, tous de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"F.X.Lamontagne Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1.000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14669-58) Gale Realties & Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Morris Chaikclson, Seymour Macblovitch, avocats, Morris Shuter, gérant de bureau, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous le nom de \"Gale Realties & Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune*.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14532-58) Goubaud de Paris (Québec) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross et Rollin Gallay, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits de beauté, sous le nom de \"Goubaud de Paris (Québec) Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 600 actions ordinaires de $10 chacune et 340 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.The head office of the corporation will be at.884 Haut-boc, Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14816-58) F.X.Lamontagne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Laurent Lamontagne, contractor, Gérard Sylvain, accountant, and Miss Monique Lamontagne, housewife, all of Quebec, for the following purposes: To carry on business as general building contractors under the name of \"F.X.Lamontagne Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General,, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14669-58).Gale Realties & Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutennat-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Morris Chaikelson, Seymour Machlovitch, avocates, Morris Shuter, office manager, and Nicole Paternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and development company, under the name of \"Gale Realties & Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14532-58) Goubaud de Paris (Québec) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross and Rollin Gallay, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in beauty products, under the name of \"Goubaud de Paris (Québec) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 600 common shares of $10 each ad 340 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney .General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General. 742 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N* 7 (P.G.14536-58) Gren Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Hilliard Ginsberg, avocat, Gabriel Glazer, étudiant en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à transporter des passagers et des marchandises, sous le nom de \"Gren Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1440 rue Towers, chambre 100, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14824-58) Grondines & Frère Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Martin Grondines, Léonce Grondines, entrepreneurs, et Léona Proulx Grondines, ménagère, épouse séparée de biens dudit Léonce Grondines, tous de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Grondines & Frère Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 809, rue des Lilas, est, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14582-58) Howrich Motors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1958, constituant en corporation: Bernard Diamond, Harold Gossack, Jason Ruby, tous trois avocats, et Alan Golden, commis, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce de manufacturiers, marchands et distributeurs de toutes sortes d'automobiles et autres fournitures motorisées et exploiter des garages, sous le nom de \"Howrich Motors Ltd.\": avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8945 rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14535-58) Gren Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Hilliard Ginsberg, advocate, Gabriel Glazer, law student, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of transporting passengers and goods, under the name of \"Gren Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1440 Towers Street, Room' 100, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14824-58) Grondines & Frère Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Martin Grondines, Léonce Grondines, contractors, and Léona Proulx Grondines, housewife, wife separate as to property of the said Léonce Grondines, all of Quebec, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Grondines & Frère Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 809 des Lilas Street, East, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14582-58) Howrich Motors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by t he Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1958, incorporating: Bernard Diamond, Harold Gossack, Jason Ruby, all three advocates, and Alan Golden, clerk, all of Montreal, for the following purposes: To carry on trade and business as manufacturers and dealers and distributors of all kinds of automobiles and other automotive equipment and to operate garages, under the name of \"Howrich Motors Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 8945 Lajeunesse Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. 'QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1959, Vol.91, No.7 743 (P.G.14672-58) Inland Land Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1968, constituant en corporation: Abraham Feiner, Albert Marcus, Isidore Reuben Prazoff, avocats, et Myrna Katz, secrétaire, célibataire, tous de Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction, développement et amélioration, sous le nom de \"Inland Land Development Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 9,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.49851-o (A.G.14572-58) Inland Land Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Abraham Feiner, Albert Marcus, Isidore Reuben Prazoff, advocates, and Myrna Katz, secretary, spinster, all of Montréal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, development and improvement company, under the name of \"Inland Land Development Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 9,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, Acting Deputy Attorney General.(P.G.14612-58) Institut St-André Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec .des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Va 11 i ère, comptable, de Québec, Dr André Beauchesne, médecin, M.l'abbé Roland Dufour, ptre, chapelain, de Roberval, pour les objets suivants: Promouvoir le bien-être social des jeunes ariérés mentaux, sous le nom de \"Institut St-André Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $2,000,000.Le siège social de la corporation sera à Rober-val, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(A.G.14612-58) Institut St-André Inc.(P.G.14587-58) Island Automotive Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Arthur Leclaire, vendeur, de Ste-Rose, Louis Leclaire, gérant, de Châteauguay Bassin, et Mariette Leclaire, teneuse de livres, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'automobiles et autres véhicules; exercer le commerce de garagistes et quincailliers sous le nom de \"Island Automotive Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lau-rent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.Notice is hereby given that under Part III o the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Jean Val Here, accountant, of Quebec, Dr.André Beauchesne, physician, Rev.Abbé Roland Dufour, priest, chaplain, of Roberval, for the following purposes: To further the social welfare of backward youth, under the name of \"Institut St-André Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $2,000,000.The head office of the corporation will be at Roberval, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14587-58) Island Automotive Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Arthur Leclaire, Salesman, of Ste.Rose, Louis Leclaire, manager, of Châteauguay Bassin, and Mariette Leclaire, bookkeeper, spinster of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles and other vehicles; to carry on business as garage keepers and ironmongers, under the name of \"Island Automotive Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the compagny will be at St.Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, Acting Deputy Attorney General.L'Assistant procureur-général suppléant, 49851 P.FRENETTE.49851-0 744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1959, Tome 91, N° 7 (P.G.14966-58) J.A.I.cvesque Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, eh date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Henri Beaudry, de St-Romuald, Gaston Midiaud et Gabrielle Vallée, célibataire, de Québec, tous avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents d'assurances, sous le nom de \"J.A.Lcvcsque Inc.\", avec un capital total de $40,090, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 502 1ère Avenue, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14660-58) Jasper Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958.constituant en corporation: John Maria Ccrini, conseil en loi de la Reine, Paul-Denis Martel, tous deux de Montréal, et Robert Lcarmont Jamicson, de Pointe Claire, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer, le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Jasper Construction Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8255 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14083-58) J.A.Vincent Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: J.-Adhémar Vincent, courtier, Candide Ledoux, ménagère, épouse séparée de biens dudit J.-Adhémar Vincent, et Jeannine Vincent, ménagère, épouse séparée de biens de Richard Riéux, tous des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtier en assurance et agir comme agents d'assurance, sous le nom de \"J.A.Vincent Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.(A.Ç.14966-58) J.A.Levesque Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating: Henri Beaudry, of St-Romuald, Gaston Mi chaud and Gabrielle Vallée, spinster, of Quebec, all advocates, for the following purposes: To carry on business as insurance agents, under the name of \"J.A.Levesque Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 502 1st Avenue, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14660-58) Jasper Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'- Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: John Maria Cerini, Queen's Counsel, Paul-Denis Martel, both of Montreal, and Robert Learmont Jamieson, of Pointe Claiie, all advocates, for the/ following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Jasper Construction Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will he at 8255 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.140S3-58) J.A.Vincent Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: J.-Adhémar Vincent, broker, Candide Ledoux, housewife, wife separate as to proj>erty of the said J.-Adhémar Vincent, and Jeannine Vincent, housewife, wife separate as to property of Richard Rioux.all of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on a business as insurance broker and to operate as insurance agents, under the name of \"J.A.Vincent Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE; Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 745 (Ptf.14823-58) J.M.Clément Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: André Clément, marchand, de Ste-Foy, Annette Vaillancourt Clément, ménagère, épouse séparée de biens de Jean-Marie Clément, de St-Nicolas, et Michel Clément, vendeur, de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de vêtements, sous le nom de \"J.M.Clément Ltée\", avec un,capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2797, boulevard Laurier, Saintc-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14821-58) Jutex Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, Morris Chai-kelson, avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous le nom de \"Jutex Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera) à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureUr général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14744-58) Kir-Gar Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Simon Kirsch, fourreur, Laura Frishling, secrétaire, fille majeure, et usant de ses droits, Philip S.Garoncc et Laddie H.Schnaibcrg, tous deux avocats, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et les activités de constructeurs et entrepreneurs généraux et gérer tous commerces de placements, sous le nom de \"Kir-Gar Investments Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.- L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14823-58) J.M.Clément Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of 'December, 1958, incorporating: André Clément, merchant, of Ste-Foy, Annette Vaillancoxirt Clément, housewife, wife separate as to property of Jean-Marie Clement, of St-Nicolas, and Michel Clément, salesman, of Quebec, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in clothing, under the name of \"J.M.Clément Ltée\", with a total capital itock of $40,000, divided itno 400 shares of 8100each.The head office of the company will be at 2797 Laurier Boulevard, Sainte-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14821-58) Jutcx Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chailkelson, advi-cates, and Nicole Peternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and development company, under the name of \"Jutex Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14744-58) Kir-Gar Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies^Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Simon Kirsch, furrier, Laura Frishling, secretary, fille majeure et usant de ses droits, Philip S.Garonce and Laddie H.Schnaiberg, both advocates, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and activities of general builders and contractors, and to operate all investment businesses, under the name of \"Kir-Gar Investments Ltd.\", with a total capital stock\" of $10,000, divided into 400 common shares of $10 each and 600 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, ^ 49851-0 Acting Deputy Attorney General. 746 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1969, Tome 91, N° 7 (P.G.14649-58) La Ganterie Beauceronne Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le.Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Jean-Jules Fiset, industriel, Grégoire Poulin, comptable, tous deux de St-Georgcs, et Geo.-Octave Poulin, agent d'assurances, de St-Martin, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de gants et mitaines, sous le nom de \"La Ganterie Beauceronne Ltée\", avec un capital total de $100,000, divise en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Martin, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14640-58) La' Tribune de la Presse du Parlement de Québec The Quebec Parliamentary Press Gallery Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Vincent Prince, de Montréal, Fernand Renault, de Ste-Pétronille, Ile d'Orléans, Adalbert Trudel, de Québec, et Henri Dutil, de St-Romuald, tous journalistes, pour les objets suivants: Grouper en association les journalistes qui sont assignés au Parlement de Québec, sous le nom de \"La Tribune de la Presse du Parlement de Québec \u2014 The Quebec Parliamentary Press Gallery\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels de la corporation est de $500.Le siège social de la corporation sera à Québec, .district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14534-58) L'Auberge du Port Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat, Lucille Roy et Louise Bourdon, secrétaires, célibataires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tenanciers d'hôtels, motels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de \"L'Auberge du Port Inc.\", avec un capital total de $110,000, divisé en 1,000 actions communes d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au .pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7881, boulevard Décarie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(A.G.14549-58) La Ganterie Beauceronne Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Jean-Jules Fiset, industrialist, Grégoire Poulin, accountant, both of St.Georges, and Geo-Octave Poulin, insurance agent, of St.Martin, for the following purposes: To carry on the business of and deal in gloves and mitts, under the name of \"La Ganterie Beauceronne Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint Martin, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14640-58) La Tribune de la Presse du Parlement de Québec The Quebec Parliamentary Press Gallery Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Vincent Prince, of Montreal, Fernand Renault, of Ste-Pétronille, Island of Orleans, Adalbert Trudel, of Quebec, and Henri Dutil, of St-Romuald, all journalists, for the following purposes: To group into an association the journalists who are assigned to the Parliament of Quebec, under the name of \"La Tribune de la Presse du Parlement de Québec \u2014 The Quebec Parliamentary Press Gallery\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $500.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14534-58) L'Auberge du Port Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Maurice Martel, advocate, Lucille Roy and Louise Bourdon, secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of keepers of hotels, motel, taverns, inns and restaurants, under the name of \"L'Auberge du Port Inc.\", with a total capital stock of $110,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 1,000 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 7881 Dccarie Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 747 (P.G.14649-58) Léo Lorrain Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Jean Monet, Gérald McCarthy, avocats, et Mary Elizabeth Spracklin, secrétaire majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: * Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme tenanciers d'hôtels, restaurants, auberges, boulangeries, tavernes et garages, sous le nom de \"Léo Lorrain Inc.\", avec un capital total de $2,000,000, divisé en 19,990 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera 203, Place Youville, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14433-58) Les Entreprises Port-Royal Inc.Port-Royal Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1958, constituant en corporation: Rosarîo Hotte, marchand, Jeanne Hotte, marchande, épouse contractuellement séparée de biens de Willie Reeves, et dûment autorisée par lui, et Louise Hotte, marchande, épouse contractuellement séparée de biens de Gabriel d'Anjou, et dûment autorisée par lui, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille \"holding\", sous le nom de \"Les Entreprises Port-Royal Inc.\u2014 Port-Royal Enterprises Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 11745, rue Tolhurst, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14436-58) Les Frères des Ecoles Chrétiennes de Longueuil Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Arthur Bonenfant, Albert Matte et Albert Granger, tous membres des frères des écoles chrétiennes, de Montréal, pour les objets suivants: Poursuivre des fins religieuses, éducationnelles et scientifiques, sous le nom de \"Les Frères dès Écoles Chrétiennes de Longueuil\".Le montant auquel sont limités les revenus provenant des immeubles que pourra acquérir et posséder la corporation, est de $1,000,000.(A.G.14649-58) Léo Lorrain Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December 1958, incorporating: Jean Monet, Gerald McCarthy, advocates, and Mary Elizabeth Spracklin, secretary of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate; carry on business as keepers of hotels, restaurants, inns, bakeries, taverns and garages, under the name of \"Léo Lorrain Inc.\", with a total capital stock of $2,000,-000, divided into 19,990 preferred shares of a par value of $100 each and 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 203 .Youville Square, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14433-58) Les Entreprises Port-Royal Inc.Port-Royal Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1958, incorporating: Rosario Hotte, merchant, Jeanne Hotte, merchant, wife contractually separate as to property of Willie Reeves, and duly authorized by him,'and Louise Hotte, merchant, wife contractually separate as to property of Gabriel d'Anjou, and duly authorized by him, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and holding company, under the name of \"Les Entreprises Port-Royal Inc.\u2014 Port-Royal Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of a par value of $100 each and 5,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 11745 Tolhurst Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14436-58) Les Frères des Écoles Chrétiennes de Longueuil Notice is hereby given that under Part TU of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Arthur Bonenfant, Albert Matte and Albert Granger, all members of the Christian Brothers' Schools, of Montreal, for the following purposes: To pursue, for religious, educational and scientific purposes, under the name of \"Les Frères des Écoles Chrétiennes de Longueuil\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $1,000,000._ 748 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1959, Tome 91, N° 7 Le siège social de .la corporation sera à Lon- Seuil, comté de Chèmbly, district judiciaire de ontréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.The head office of the corporation will be at Longueuil, county of Chambly, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14650-58) Les Habitations Gentilly Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Armand-G.Boisclair, industriel, Juliette Mailloux, secrétaire, célibataire majeure, et .Jacques Viger, commis, tous de Montréal, pour les objets suivants: Agir et faire affaires comme compagnie de logements à dividendes limités telle que définie par la loi nationale de 1954 sur l'habitation, et 6cs amendements (2-3 Elizabeth II, ch.23), sous le nom de \"Les Habitantions Gentilly Inc.\", avec un total de $300,000, divisé en 30.000 actions communes d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Longueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(A.G.14650-58) Les Habitations Gentilly Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Armand-G.Boisclair, industrialist, Juliette Mailloux, secretary, spinster, of full age of majority, and Jacques Viger, clerk, all of Montreal, foi the following purposes: To act and carry on business as a housing company with limited dividends such as defined in the 1954 National Housing Act, and amendments thereto (2-3 Elizabeth 11, chap.23), under the name of \"Les Habitations Gentilly Inc.\", with a total capital stock of $300,000, divided into 30,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14619-58) Les Loisirs Jean Le Prévost Inc.Avis est donné qu'en vertu delà troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes,' en date du onze décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Polydore Roy, assurance générale, Louis L'Heureux, publiciste, Robert Comeau, enrobeur de piiules, Lucien Paradis, commis, Normand Chevricr, opticien d'Ordonnance, Rév.Père Raoul Cyr, supérieur, et Jean-Claude Fortin, pompier, tous de Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger un centre de loisirs, sous le nom de \"Les Loisirs Jean Le Prévost Inc.\".s\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $40,000.Le siège social de la corporation sera 5707, rue St-Dominique, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14648-58) Lew Kozlov Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous (A.G.14619-58)- Les Loisirs Jean Le Prévost Inc.Notice is hereby given that under Part in of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Polydore Roy, general insurance, Louis L'Heureux, publicist, Robert Comeau, pill-coatcr, Lucien Paradis, clerk, Normand Chevrier, prescribing optician, Rev.Father Raoul Cyr, superior, and Jean-Claude de Fortin, fireman, all of Montreal, for the following purposes: To establish and direct a recreational center, under the name of \"Les Loisirs Jean Le Prévost Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $40,000.The head office of the corporation will be at 5707 St-Dominique Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14648-58) Lew Kozlov Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the.town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 749 le nom de \"Lew Kozlov Realties Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14645-58) L'Oeuvre des Loisirs de Plessisvillc, Inc.-Ayis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a étè^accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Gustave Bois-sonnault, comptable, Dr Raymond Charron, médecin, Charles Germain, Raymond Rouillier, marchands,' Georges Dumaine, contremaître, J.-Onésime Dubois, surintendant, et Simon Montambault, mouleur, tous de Plessisvillc, pour les objets suivants: Établir et diriger un centre de loisirs, sous le nom de \"L'Oeuvre des Loisirs de Plcssisville, Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $200,000.Le siège social de la corporation sera à Plcssisville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du .Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14537-58) Lou Boudrias Sales Co.Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Lucien Boudrias, marchand, de Valois, Lisette Lambert, secrétaire, fille majeure, et Gregory Charlap, avocat, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer ou autrement faire le commerce d'accessoires ou outillage motorisés, fournitures de garage, appareils électriques, quincaillerie, dispositifs de fixation, marchandises de sport et autres marchandises de même nature, sous le nom de \"Lou Boudrias Sales Co.Ltd.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 30 actions ordinaires de $100 chacune et 270 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Valois, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14738-58) ~~ Marvel Development Corp.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Irwin Gliserman, Moe Ackman, avocats, et Doreen Weldon, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: the name of \"Lew Kozlov Realties Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 36,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14645-58) L'Oeuvre des Loisirs de Plessisvillc, Inc.Notice is hereby given that under Part DT of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Jean-Gustave Boissonnault, accountant, Dr Raymond Charron, physician, Charles Gervais, Raymond Rouillier, merchant, Georges Dumaine, foreman, J.-Onésime Dubois, superintendent, and Simon Montambault, moulder, all of Plcssisville, for the following purposes: To establish and conduct a center of recreational activities, under the name of \"L'Oeuvre des Loisirs de Plessisvillc, Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $200,000.The head office of the corporation will be at Plcssisville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14537-58) Lou Boudrias Sales Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the' Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Lucien Boudrias, merchant, of\u2014Valois, Lisette Lambert, secretary, spinster of the full age of majority, and Gregory Charlap, advocate, both of Montreal, for the following purposes: To manufacture and otherwise deal in automotive accessories and equipment, garage supplies, electrical appliances, hardware, fastening devices, sporting goods and other merchandise of like nature, under the name of \"Lou Boudrias Sales Co.Ltd.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 30 common shares of $100 each and 270 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Valois, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14738-58) Marvel Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Irwin Gliserman, Moe Ackman, advocates, and Doreen Weldon, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: 750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février Î969, Tome 91, N* 7 Exercer le commerce d'une compagnie de To carry on the business of a land, construc- terrains, construction et amélioration, sous le tion and improvement company, under the name nom de \"Marvel Development Corp.\", avec un of \"Marvel Development Corp.\", with a total capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions capital stock of $20,000, divided into 1,000 ordinaires de $10 chacune et 100 actions privilé- common shares of $10 each and 100 preferred giées de $100 chacune.shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, dix-neuf décembre 1958.this nineteenth day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49851 P.FRENETTE.49851-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14643-58) Master Construction Company Limited' Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Shorteno, tous deux de ville Mont-Royal, et Bruno Pateras, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Master Construction Company Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 10405 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14573-58) Mendel Investments Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1958, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, avocat et conseil en loi de la Reine, Benjamin J.Greenberg, étudiant, et Mary Watt, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Mendel Investments Corp.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 9,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14542-58) Mike Spaghetti House Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Mario Beaulieu, Raphaël Esposito, notaires, et Filippo Zunini, étudiant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"Mike Spaghetti House Inc.\", avec un (A.G.14643-58) Master Construction Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Albert Malouf, Peter Shorteno, both of the town of Mount'Royal, ad Bruno Pateras, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Master Construction Company Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common snares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company wiH be at 10405 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14573-58) Mendel Investments Corp.N'otice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1958, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, Benjamin J.Greenberg, student, and Mary Watt, secretary, spinster of the full age-of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Mendel Investments Corp.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 9,000 preferred shares of a par value of $10 each and 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attornye General.(A.G.14542-58) Mike Spaghetti House Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Mario Beaulieu, Raphaël Esposito, notaries, and Filippo Zunini, student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"Mike Spaghetti House Inc.\", QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February l#h, 1959, Vol.91, No.7 751 capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 3900 Avenue Wellington, Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 ' P.FRENETTE.(P.G.14668-58) Mill-Hill Development Corp.Avis est donné' qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation : Harry Kerdman, Nathan Kerdman, fabricants, Philip S.Garonce et Laddie H.Schnai-berg, avocats, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Mill-Hill Development Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14304-58) Montreal Overseas Trading Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Daniel Kingstone, avocat, Joseph Nuss, étudiant, tous deux de Montréal, et Katherine Ingledew, sténographe, célibataire, de St-Lau-rent, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits, articles et marchandises fabriqués en tout ou en partie de cuir, caoutchouc métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre, et sous-produits d'iceux, mercerie, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et revues périodiques, peintures, travaux artistiques produits alimentaires, chimiques et de beauté, produits de la terre, de la mer et de la forêt, sous le nom de \"Montreal Overseas Trading Company\", avec un capital total de $5,000, divisé en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14382-58) Montreal Security Service Bureau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Philippe Côté, agent, Paul-Emile Poitras, with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at 3900 Wellington Avenue, Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14668-58) \" Mill-Hill Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Harry Kerdman, Nathan Kerdman, manufacturers, Philip S.Garonce and Laddie H.Schnaiberg, advocates, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Mill-Hill Development Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided mto 400 common shares of $10 each and 600 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14304-58) Montreal Overseas Trading Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Daniel Kingstone, advocate, Joseph Nuss, student, both of Montreal, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster, of St.Laurent, for the following purposes: To deal in products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products of same, haberdashery, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, paintings, works of art, food, chemical and beauty products, land, sea and forest products, under the name of \"Montreal Overseas Trading Company\", with a total capital stock of $5,000, divided into 400 preferred shares of a par value of $10 each and 100 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14382-58) Montreal Security Service Bureau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Philippe Côté, agent, Paul-Émile Poitras, investigator, 752 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 14 février 1969, Tome 91, N* 7 investigateur, Georges Bilodeau, avocat, Françoise De Celles, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, tous quatre de Montréal, et Bernard Bilodeau, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Établir, maintenir une agence générale pour fins d'enquêtes et d'informations et de renseignements sur la valeur financière, la réputation, les affaires, la responsabilité d'individus, associations, entreprises, corporations, sous le nom de \"Montreal Security Service Bureau Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district iudiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.Georges Bilodeau, advocate, Françoise De Celles, secretary, of full age of majority making use of her rights, all four of Montreal, and Bernard Bilodeau, advocate, of Westmount, for the following purposes: To establish and maintain a general agency for investigations, information, and particulars regarding the financial status, reputation, business \u2022concerns, responsibility of individuals, associations, undertakings and corporations, under the name of \"Montreal Security Service Bureau Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40.000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14652-58) Natalie-Vine Blouse Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Morris Rothstein, marchand, Jack Green-stein, avocat, et Pinchas Blitt, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce ou le négoce de cotons, lainages, soies, toiles, tissus, vêtements et articles vestimentaires de tous genres, sous le nom de \"Natalie-Vine Blouse \u2022 Corporation\",-avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14574-58) Nor-Ben Investment Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de il province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation: Max M.Teitlebaum, Irving I.Finkelberg et Alfred N.Segal, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Nor-Ben Investment Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 2,850 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2315 rue Beaudet, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.(A.G.14652-58) Natalie-Vine Blouse Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Morris Rothstein, merchant, Jack Greenstein, advocate, and Pinchas Blitt, law student, all of Montreal, for the following purposes: ._.To manufacture and deal in or with cottons, woollens, silks, linens, fabrics, and clothing and wearing apparel of every sort, under the name of \"Natalie-Vine Blouse Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14574-58) , Nor-Ben Investment Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Icttrts patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Max M.Tei-telbaum, Irving I.Finkelberg and Alfred N.Segal, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Nor-Ben Investment Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of a par value of $10 each, 2,850 Class \"A\" preferred shares of a par value of $10 each and 1,000 Class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 2315 Beaudet Street, Saint Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Lfth, 1959, Vol.91, No.7 763 (P.G.14764-68) Nordic Compagnie Limitée Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Germain Lucier, commerçant, M ligue tte Gagné, secrétaire, célibataire, tous deux de Joliette, et Jacques Théroux, comptable, de Crab tree Mills, pour les objets suivants: Exercer le commerce des marchandises suivantes: quincaillerie, pièces et accessoires d'automobile, jouets, nouveautés, chaussures et vêtements, appareils électriques et instruments de musique, meubles, bois, appareils de navigation, ainsi que le commerce de garagistes et de restaurateurs, sous .le nom de \"Nordic Compagnie Limitée\", avec un capital total de 185,000, divisé en 650 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14528-58) Noremac Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958 constituant en corporation: B.Robert Benson, étudiant en droit, Yvonne Bélanger et Sylvia Vineberg, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Noremac Investments Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de'Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14581-58) Norfin Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation: Irving I.Finkelberg, Max M.Teitelbaum et Alfred N.Segal, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de Elacements, sous le nom de \"Norfin Investments td.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 5,900 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $10 chacune et 4,000 actions, privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 265 ouest, rue Craig, suite 430, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14764-58) Nordic Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Germain Lucier, merchant, Muguette Gagné, secretary, spinster, both of Joliette, and Jacques Théroux, accountant, of Crabtree Mills, for the following purposes: , To deal in the following merchandise: hardware, automobile parts and accessories, toys, novelties, footwear and wearing apparel, electrical apparatus musical instruments, furniture, wood, navigational instruments, as well as the business of garage-keepers and restaurateurs, under the name of \"Nordic Compagnie Limitée\", with a total capital stock of $85,000, divided into 650 common snares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14528-58) Noremac Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: B.Robert Benson, law student, Yvonne Bélanger and Sylvia Vineberg, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Noremac Investments Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985 l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14581-58) Norfin Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Irving I.Finkelberg, Max M.Teitelbaum and Alfred N.Segal, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Norfin Investments Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100 common-shares of a par value of $10 each, 5,900 Class \"A\" preferred shares of a par value of $10 each and 4,000 Class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 265 Craig Street West, Suite 430, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-0 Acting Deputy Attorney General.\" 754 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1959, Tome 91, N\" 7 (P.G.14646-58) (A.G.14646-58) Pathways Inc.Pathways Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat, Lucille Roy et Louise Bourdon, secrétaires célibataires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de producteurs, d'éditeurs et distributeurs de projections animées, sous le nom de \"Pathways Inc.\", avec un capital total de $150,000, divisé en 5,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune et en 1,450 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3460, rue Simpson, appartement 601, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14527-58) Penidas Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Maurice Martel, advocate, Lucille Roy and Louise Bourdon, secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of producers, editors of moving-pictures, under the name of \"Pathways Inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 1,450 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 3460 Simpson Street, Apartment 601, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14527-58) Penidas Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the.eleventh du onze décembre 1958, constituant en corpora- day of December, 1958, incorporating: Neil tion: Neil Phillips, avocat, Yvonne Bélanger, Phillips, advocate, Yvonne Bélanger, Sylvia Sylvia Vineberg, toutes deux propriétaires, Vineberg, both Secretaries, filles majeures, all filles majeures, tous trois de Montréal, et God- three of Montreal, and Godfroy Marin, advocate, froy Marin, avocat, de Pointe Claire, pour les of Pointe Claire, for the following purposes: objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, To purchase or otherwise acquire and to hold, posséder, y construire, et développer des pro- own, build on, and develop immoveable propriétés immobilières et immeubles à des fins de perty and real estate for investment purposes, placements, et agir comme bailleurs et adminis- and to act as lessors and administrators in con-trateurs en ce qui se rapporte à iceux, sous le nection therewith, under the name of \"Penidas nom de \"Penidas Investments Ltd.\", avec un Investments Ltd.\", with a total capital stock capital total de $1,000, divisé en 100 actions de of $1,000, divided into 100 shares of $10 each.$10 chacune.\\ The head office of the company will be at Le siège social de la compagnie sera à Montréal, Montreal, judicial district of Montreal, district judiciaire de Montréal.(P.G.14437-58).\\ (A.G.14437-58) N.Smith Limitée N.Smith Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec des lettres patentes, en date du Province of Quebec, bearing date the eighteenth dix-huit décembre 1958, constituant en corpora- day of December, 1958, incorporating: Antonio tion: Antonio Denis, Robert Lacaille, vulcanisa- Denis, Robert Lacaille, vulcanizing operators, and teurs, et Raoul Dompierre, gérant de service, Raoul Dompierre, service-manager, all of Mont-tous de Montréal, pour les objets suivants: real, for the following purposes: Exercer l'industrie et le commerce d'automo- To carry on the business of and deal in auto-biles et autres moyens de transport; exercer le mobiles and other means of transportation; deal commerce du transport de passagers et de mar- in the transportation of passengers and goods; ch an dises; faire affaires comme garagistes et carry on business as garage-keepers and hard-quincailliers, sous le nom de \"N.Smith Limitée\", waremen, under the name of \"N.Smith Limitée\", avec un capital en 1,000 actions sans valeur with a capital stock divided into 1,000 shares nominale et en 700 actions privilégiées de $50 witnout nominal or par value and 700 preferred chacune, et le montant avec lequel la compagnie shares of $50 each, and the amount with which the commencera ses opérations sera de $10,000.company shall commence its operations will be $10,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le dix- Dated at the office of the Attorney General, huit décembre 1958.this eighteenth day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49851-0 P.FRENETTE.49851 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February l#h, 1969, Vol.91, No.7 755 Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14616-58) Placements Dorion Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert Dulude, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille (holding), sous le nom de \"Placements Dorion Investments Inc.\", avec un capital divisé en 200 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera d'au moins $4,000.Le siège social de la compagnie sera à Dorion, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14270-58) Plenta Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Max S.Kaufman, Joseph Roy Hoffman et Oscar Respitz, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Plenta Development Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 'actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14658-58) \" Plymouth Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corpor-tion : John Maria Cerini, conseil en loi de la Reine, Paul-Denis Martel, tous deux de Montréal, et Robert Le ami ont Jamieson, de# Pointe Claire, tous avocats, pour les oh j tes suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Plymouth Construction Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8255 Boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958?P.FRENETTE, 98451-o Acting Deputy Attorney-General.(A.G.14616-58) ~\" Placements Dorion Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Dulude, of Dorion, and Robert-Y.Lanthier, of Ste-Rose, all advocates, for the following purposes: To carry on a business as an investment and holding company under.the name of \"Placements Dorion Investments Inc.\", with a capital stock divided into 200 shares without nommai or par value and into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each, and the amount with which the company shall start its operations shall be at least $4,000.The head office of the company will be at Dorion, judicial district of Montreal.Dated at the office'of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14270-58) Plenta Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Max.S.Kaufman, Joseph Roy Hoffman and Oscar Respitz, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Plenta Development Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14658-58) Plymouth Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: John Maria Cerini, Queen's Counsel, Paul-Denis Martel, both of Montreal, and Robert Learmont Jamieson, of Pointe Claire, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Plymouth Construction Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at 8255 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. 756 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7 (P.G.14605-58) Preston's Physical Culture Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouvcrenur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Murray B.Spiegel, de Montréal ouest, Samuel H.Shriar, de St-Laurcnt, tous deux avocats, et Maxilien Polak, étudiant en droit, de Montréal, pour les objets suivants: Gérar un studio de culture phsyique, sous le nom de \"Preston's Physical Culture Inc.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14526-58) .Proteus Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Neil Phillips, avocat, Yvonne Bélanger, Sylvia Vineberg, toutes deux secrétaires, filles mejeures, tous trois de Montréal, et Godfroy Marin, avocat, de Pointe Claire, pour les objets suivants: Achater ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer des propriétés immobilières et immeubles à des fins de placements, et agir comme bailleurs et administrateurs en ce qui se rapporte à iccux, sous le nom de \"Proteus Investments Ltd.\", avec un capital total de $1,000, divisé en 100 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14666-58) Pyramid Realties Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Samuel H.Shriar, avocat, de St-Laurent, Max Polak, étudiant en droit, et Mollie Schwartz, secrétaire, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'agents d'immeubles, sous le nom de \"Pyramid Realties Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14605-58) - Preston's Physical Culture Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor.of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Murray B.Spiegel, of Montreal West, Samuel H.Shriar, of St.Laurent, both advocates, and Maxilien Polak, law student, of Montreal, for the following purposes: To direct a studio of physical culture, under the name of \"Preston's Physical Culture Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14526-58) Proteus Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Neil Phillips, advocate, Yvonne Bélanger, Sylvia Vineberg, both secretaries, filles majeures, all three of Montreal, and Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable property and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Proteus Investments Ltd.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 100 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14666-58) Pyramid Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Samuel II.Shriar, advocate, of St.Laurent, Max Polak, law student, and Mollie Schwartz, secretary, both of Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate agents, under the name of \"Pyramid Realties Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common snares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Wh, 1959, Vol.91, No.7 757 (P.G.14604-58) Quality Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Leonard Li verm an, Julius Briskin, Arthur Yanofsky, avocats, et Max Shricr, commis, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains et amélioration, sous le nom de \"Quality Investment Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 800 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14297-58) Quebec Camp for Diabetic Children Inc.Camp pour Enfants Diabétiques de Québec, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Alan Simpson, Ross, de Westmount, Eleanor R.Mackenzie Harpur, épouse cent rituellement séparée de biens de Robert Peter Harpur, de Pointe Claire, Donald Arthur Hillman, de Montréal Ouest, Guy Ernest Joron, d'Outremont, Mimi Madeleine, Bclmonte, Eleanor Elizabeth McGarry, filles majeures, Norman Jacob Nadler, tous trois de Montréal, et Johannes Christian Beck, dé Ville Mont-Royal, tous médecins, pour les objets suivants: Promouvoir, commanditer, établir, assister, développer, entretenir et déployer un programme pour rétablissement -d'un camp pour enfants diabétiques, sous le nom de \"Quebec Camp for Diabetic Children Inc.\u2014 Camp pour Enfants Diabétiques de Québec, Inc.\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $200,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14598-58) Québec Véhicules Inc.Quebec Vehicles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq décembre 1958, constituant en corporation: E.-Bert Le May, représentant médical, Olivier Chambre, représentant d'impression, et Marc-André Drouin, avocat, tous de Ste-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes; exercer le commerce d'automobiles et autre svéhicules, sous le nom de \"Québec Véhicules Inc.\u2014 Quebec (A.G.14604-58) Quality Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letter's patent have ¦ been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Leonard Liverman, Julius Briskin, Arthur Yanofsky, advocates, and Max Shrier, Clerk, all of Montreal, for the following purposes: To carry-on the business of a land and improvement company, under the name of \"Quality Investment Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,200 preferred shares of a par value of $10 each and 800 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 -o -Acting Deputy Attorney General.(A.G.14297-58) Quebec Camp for Diabetic Children Inc.Camp pour Enfants Diabétiques de Québec, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies 'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, to incorporate, as a corporation without share capital: Alan Simpson Ross, of Westmount, Eleanor R.Mackenzie Harpur, wife contractually separate as to pro-petty of Robert Peter Harpur, of Pointe Claire, Donald Arthur Hillman, of Montreal West, Guy Ernest Joron, of Outremont, Mimi Madeleine Belmonte, Eleanor Elizabeth McGarry, spinsters of age of majority, Norman Jacob Nadler, all three of Montreal, and Johannes Christian Beck, of the Town of Mount Royal, all Physicians, for the following purposes: To promote, sponsor, establish, assist, develop, -maintain and expand a program for the establishment of a Camp for diabetic children, under the name of \"Quebec Camp for Diabetic Children Inc.\u2014 Camp pour Enfants Diabétiques de Québec, Inc.\".The amount to-which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $200,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14598-58) Québec Véhicules Inc.Quebec Vehicles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of December 1958, incorporating: E.-Bert Le May medical representative, Olivier Chambre, printing representative, and Marc-André Drouin, advocate, all of Ste.Foy, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers; deal in automobiles and other vehicles, under the name of \"Québec Véhicules Inc.\u2014 Quebec Vehi- 768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1959, Tome 91, N° 7 Vehicles Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 10,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le cinq décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.des Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14825-58) Quille - O - Drome Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Julien Ferland, voyageur, de Lau-zon, Gilbert Ferland, Emery Ferland, voyageurs, et Raymond Ferland, commis, tous trois de Lé-vis, pour les objets suivants: Exercer le commerce consistant à fournir de l'amusement au public, sous le nom de \"Quille -O - Drome Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 30, rue Dorval, Levis, distruct judiciaire, de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(A.G.14825-58) Quille - O Drome Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958.incorporating: Julien Ferland, traveller, of Lauzon, Gilbert Ferland, Emery Ferland, travellers, and Raymond Ferland, clerk, all three of Levis, for the following purposes: Carry on a business consisting of providing amusements for the public, under the name of \"Quille - O - Drome Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 30 Dorval Street, Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14565-58) Quilles Pie IX Inc.Pie IX Bowling Inc.(A.G.14566-58) \u2022 Quilles Pie IX Inc.Pie IX Bowling Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation: Paul Coulombe, entrepreneur, Roger Journault.bijoutier, tous deux de St-Michel, et Laurent Blanchette, couvreur, de Montréal, pour les objets suivants: Construire, aménager, exploiter ou louer une ou plusieurs salles de jeu de quilles ou de billard, ainsi qu'un ou plusieurs restaurants dans lesdites salles, sous le nom de \"Quilles Pie IX Inc.\u2014 Pie IX Bowling Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Paul Coulombe, contractor, Roger Journault, jeweller, both of St.Michel, and Laurent Blanchette, roofer, of Montreal, for the following purposes: Erect, equip, operate or rent one or several bowling alleys or pool-rooms, as well as one or several restaurants in said pinces, under the name of \"Quilles Pie IX Inc.\u2014Pie IX Bowling Inc.\", with a total capital stock cf $40,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 200 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the c< mpany will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December.1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14890-58) Ray ton Jtealties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation: John Jacob Spector, conseil en loi de la Reine,/Ben Schecter, tous deux avocats, et Margaret McMartin, commis, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et placements, sous le nom de \"Rayton Realties Inc.\", avec un cpaital total (A.G.14890-58) Rayton Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of December, 1958, incorporating: John Jacob Spector, Queen's Counsel, Ben Shec-ter, both advocates, and Margaret McMartin, clerk, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and investment company under the name of \"Rayton Realties Inc.\", with a total capital - QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Uth, 1969, Vol.91, No.7 750 de $10,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au-pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 369 ouest, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14472-58) Reichman Bros.& Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre décembre 1958, constituant en corporation: Baruch Pollack, avocat, erg, comptable agréé, tous de Mont- Golberg, chartered accuntant, all of Montreal, réal, pour les objets suivants: for the following purposes: Exploiter un poste de taxis, terrains de sta- To operate taxicab stands, parking lots, ser-tionnement, stations de service et boutique de vice stations and vehicle and motor repair shops, réparation pour véhicules et moteurs, sous le under the name of \"Trans-City Taxi Inc.\", nom de \"Trans-City Taxi Inc.\", avec un capital with a total capital stock of $40,000, divided total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires into 200 common shares of $100 each and 200 de $100 chacune et 200 actions privilégiées de preferred shares of $100 each.$100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1434 The head office of the company will be at ouest, rue Ste-Catherine, suite 203, Montréal, 1434 St.Catherine Street west, Suite 203, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, dix-neuf décembre 1958.this nineteenth day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49851 P.FRENETTE.49851-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14769-58) (A.G.14769-58) Turbo Incorporated Turbo Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have l>een été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- provir.ee de Québec des lettres patentes, en date ince of Quebec, bearing date the nineteenth day du dix-neuf décembre 1958, constituant en cor- of December, 1958, incorporating: Bcdrich Thorz, poration: Bedrich Thorz, agent de manufactu- manufacturer's agent, of the town of Mount rier, de Ville Mont-Royal, Albert Marcus et Royal, Albert Marcus and Isidore Reuben Isidore Reuben Prazoff, tous deux avocats, de Prazoff, both advocates, of Montreal, for the Montréal, pour les objets suivants: following purposes: Exercer le commerce et le négoce de toutes To carry on the business of and deal in all sortes de machineries, sous le nom de \"Turbo kinds of machinery, under the name of \"Turbo Incorporated\", avec un capital total de $20,000, Incorporated\", with a total capital stock of divisé en 250 actions ordinaires de $10 chacune $20,000, divided into 250 common shares of $10 et 1,750 actions privilégiées de $10 chacune.each and 1,750 preferred shares of $10 each.Le siège social de la compagnie sera à Ville The head office of the company will be at Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.the town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, dix-neuf décembre 1958.this nineteenth day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49851 P.FRENETTE.49851 -o Acting Deputy Attorney General. 768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1\\ février 1969, Tome 19, N° 7 (P.G.14665-58) Two Eighty-Six Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Charles Brownstein et Moses Moscovitch, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Two Eighty-Six Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,200 actions ordinaires de $10 chacune et 2,800 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-prccureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14637-58) Urban Publishing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation : Leo J.Heaps, administrateur, de Westmount, Morton Bell, avocat, de St-Laurent, et Vera Day, secrétaire, célibataire, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un éditeur de journal ou celui d'éditeur général, sous le nom de \"Urban Publishing Co.Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 1.8C0 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège sccial de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.14716-58) Viviane Hosiery Mills Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation: Didier Terkel, fabricant, Blanche Wieder Terkel, ménagère, épouse séparée de biens dudit Didier Terkel et dûment autorisée par ce dernier, et Adolf Wieder, fabricant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun des commerces de tricoteurs, tisserands, teinturiers, blanchisseurs, marchands de vêtements, tailleurs, drapiers, bonnetiers, modistes, costumiers, fourreurs, commerçants de scies, carpettes, textiles, marchandises en plastique, articles en cuir, cotons, tissus et dentelle, sous le nom de \"Viviane Hosiery Mills Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14665-58) Two Eighty-Six Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Irving L.Adessky, Charles Brownstein and Moses Moscovitch, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Two Eighty-Six Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,200 common shares of $10 each and 2,800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 4985l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14637-58) Urban Publishing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Leo J.Heaps, executive, of Wcstmount, Morton Bell, advocate, of St.Laurent, and Vera Day, secretary, spinster, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a newspaper publisher or the business of publishing generally, under the name of \"Urban Publishing Co.Ltd.', with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 1,800 preferred shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14716-58) ~ Viviane Hosiery Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958, incorporating: Didier Terkel, manufacturer, Blanche Wieder Terkel, housewife, wife separate as to property of the said Didier Terkel, and duly authorized by him, and Adolf Wieder, manufacturer, all of Montreal, for the following purposes: To carry on all or any of the businessess of knitters, weavers, dyers, bleachers, clothiers, tailors, drapers, hosiers, milliners, costumiers, furriers, dealers in silks, carpets, textiles, plastic goods, leather goods, cottons, cloths, and lace merchants, under the name of \"Viviane Hosiery Mills Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The.head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Ut h, 1969, Vol.91, No.7 769 (P.G.14220-58) Windsor Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Herbert Croll, agent d'immeubles, Saul Venetsky, comptable, Moses Levitt, fabricant, Max Louis, architecte, Ernest G.Sabloff, notaire, tous les cinq de Montréal, et Leo Gordon, marchand, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: » Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous le nom de \"Windsor Development Corp.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Prccureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(P.G.107f8-58) Witmyer Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation: Melvin Myers, fabricant, de Ville Mont-Royal, David Lack, avocat, de Montréal, et Pearl Auerbach, secrétaire, célibataire, d'Outre -mont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction, amélioration et placements, sous le nom de \"Witmyer Investments Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Prccureur général, le neuf décembre 1958.\u2022 - L'Assistant-procureur général suppléant, 49851 P.FRENETTE.(A.G.14220-58) Windsor Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Herbert Croll, realtor, Saul Venetsky, accountant, Moses Levitt, manufacturer, Max Louis, architect, Ernest G.Sabloff, notary, all five of Montreal, and Leo Gordon, merchant, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and development company, under the name of \"Windsor Development Corp.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 common shares of $1 each.-The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day 6f December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10758-58) Witmyer Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, incorporating: Melvin Myers, manufacturer, of the town of Mount Royal, David Lack, advocate, of Montreal, and Pearl Auerbach, secretary, spinster, of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction, improvement and investment company, under the name of \"Witmyer Investments Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851-o Acting Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.14584-58) Astor Arms Apartments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix décembre 1958, à la compagnie \"Astor Arms Apartments Inc.\", subdivisant et convertissant 250 actions de $100 chacune de son capital-actions en 5,000 actions privilégiées de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.12882-58) Cercueils Atlas Caskets Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplé- Supplementary Letters Patent * (A.G.14584-58) Astor Arms Apartments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of December 1958, to the company \"Astor Arms Apartments Inc.\", subdividing and converting 250 shares of $100 each an of its share capital into 5,000 preferred shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12882-58) Cercueils Atlas Caskets Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the 770 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, 7 ment ai res, en date du vingt-sept novembre 1958, à la compagnie \"Cercueils Atlas Caskets Inc.\", modifiant les dispositions de ses lettres patentes de constitution en corporation en ce qui concerne les restrictions au transfert des actions.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.13599-58) Classy Formal Wear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le .Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente et un décembre 1958, à la compagnie \"Classy Formal Wear Inc.\", augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations étant fixé à non moins de $-10,000.Daté «lu bureau «lu Prccureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.twenty-seventh day of November, 1958, to the company \"Cercueils Atlas Caskets Lie\", a-mending.the provisions of its letters patent of incorporation in that which concerns the restrictions to the transfer of shares.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13599-58) Classy Formal Wear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of.Quebec, dated thirty-first day of December 1958, to the company \"Classy Formal Wear Inc.\", increasing its capital, the additional share capital being «!ivide«l into 1,500 preferred shares «>f $100 each, and the amount with which the said company shall continue its operations being fixed at not less than $40,000.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14785-58) Cobra Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par *le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt décembre 1958, à la compagnie \"Cobra Industries Inc.\", 1° subdivisant ses 4,950 actions ordinaires de $10 chacune en 9,900 actions ordinaires de $5 chacune; 2° augmentant son capital de $49,500 à $500,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 90,100 actions ordinaires de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(A.G.14785-58) Cobra Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twentieth day of December 1958, to the company \"Cobra Industries Inc.\", 1.subdividing its 4,950 common shares of $10 each into 9,900 common shares of $5 each; 2.increasing its capital from the sum of $49,500 to $500,000, the additional share capital being divided into 90,100 common shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11065-58) Conex Corporation La Corporation Conex Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois décembre 1958, à la compagnie \"Cpnex Corporation \u2014 La Corporation Conex\", réduisant son capital «le $200,000 à $100,000, le capital-actions annulé étant divisé en 2,000 actions privilégiées de $50 chacune.Daté du bureau du Procureur général, vingt-trois décembre J958., L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.le (A.G.11065-58) Conex Corporation La Corporation Conex Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-third day of December 1958, to the company \"Conex Corporation \u2014 La Corporation Conex\" decreasing its capital stock from the sum of $200,000 to $100,000, the cancelled share capital being divided into 2,000 preferredjshares of $50 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of December 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14828-58) Custom Built Homes Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-«leux décembre 1958, à la compagnie \"Custom Built Homes Corpora- (A.G.14828-58) Custom Built Homes Corporation Notice is hereby given that under Part I of the \"Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December twenty-second, 1958, to the company .\"Custom Built Homes Corporation\", reducing its capital QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 771 tion\", réduisant son capital, le capital-actions annulé étant divisé en 13,530 actions privilégiées de $5 chacune, et le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations étant fixé à non moins de §52,255.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14782-58) Cyclorama de Jérusalem Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du seize décembre 1958, à la compagnie \"Cyclorama de Jérusalem Inc.\", 1) convertissant 50 actions ordinaires de $100 chacune en 50 actions privilégiées de $100 chacune; 2) étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14628-58) Diamond-Oslinger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze décembre 1958, à la compagnie \"Gerald Diamond Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes du 31 décembre 1957.1) changeant son nom en celui de \"Dinmond-Oslinger Inc.\"; 2) augmentant son capital de $40,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 590 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.13947-58) Diversified Investments Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première pitrtie de la Loi des compagnies de Québec, il a été âceerdé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-neuf décembre 1958, à la compagnie \"L'Abord-à-Plouffe Realty Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 31 décembre 1953, 1) augmentant son capital de $10,000 à $210,000, le capital-actions additionnel étant | divisé en 2,000 actions privilégiées de $100 chacune; 2) changeant son nom en celui de \"Diversified Investments Corporation\".Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.|(P.G.14161-58) Donald Kirk Enterprises Ltd.¦S Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Ijété accordé par le Lieutenant-gouverneur de la rovince de Québec des lettres patentes supplé- stock, the cancelled capital stock being divided into 13,530 preferred shares of $5 each, and the amount with which the said company shall continue its operations being fixed at not less than $52,255.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14782-58), Cyclorama de Jérusalem Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the sixteenth day of December 1958, to the company \"Cyclorama de Jérusalem Inc.\", 1) converting its 50 common shares of $100 each into 50 preferred shares of $100 each; 2) extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14628-58) Diamond-Oslinger Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of December 1958, to the company \"Gerald Diamond Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated December 31, 1957, 1) changing its name to that of \"Diamond-Oslinger Inc.\"; 2) increasing its share capital from the sum of $40,000 to $100,000, the additional share capital being divided into 100 common shares of $10 each and 590 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney Genera).(A.G.13947-58) Diversified Investments Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the nineteenth day of December 1958, to the company \"L'Abord-à-Plouffe Realty Limited\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated December 31, 1953, 1) increasing its capital stock from the sum of $10,000 to $210,000, the additional share capital being divided into 2,000 preferred shares of $100 each; 2) changing its name to that of \"Diversified Investments Corporation\".Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14161-58) Donald Kirk Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated.the 772 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1959, Tome 91, N° 7 ment aire s, en date du sept janvier 1959, à la compagnie \"Kirk & Lane Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, sous le nom originaire de \"Donald Kirk Enterprises Inc.\", par lettres patentes du 27 septembre 1957, et par lettres patentes supplémentaires en date du 17 avril 1958, changeant ledit nom originaire en celui de \"Kirk & Lane Inc.\", changeant de nouveau son nom en celui de \"Donald Kirk Enterprises Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le sept janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14336-58) Eastern Townships Warehousing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze décembre 1958, à la compagnie \"Eastern Townships Warehousing Ltd.'', 1) réduisant son capital par la réduction de la valeur au pair des actions privilégiées de $100 à $10 chacune, et par la réduction du nombre des actions ordinaires de 3,000 à 500; 2) fixant le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations à non moins de $7,500; 3) modifiant les dispositions des lettres patentes antérieures en ce qui concerne les privilèges attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 ^ P.FRENETTE.(P.G.13581-58) E.J.Chartier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze décembre 1958, à la compagnie \"E.J.Chartier Inc.\", modifiant les dispositions de ses lettres patentes supplémentaires du 22 octobre 1958 en ce qui concerne les droits, privilèges et restrictions attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.10445-57) Entreprises Beaubien Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente et un décembre 1958, à la compagnie \"Entreprises Beaubien Inc.\", augmentant son capital de $10,000 à $200,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 31,000 actions ordinaires de $5 chacune, 5,000 actions privilégiées, classe \"A\", de $5 chacune, et en 2,000 actions privilégiées, classe \"B\", de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.seventh day of January 1959, to the company \"Kirk & Lane Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, under the original name of \"Donald Kirk Enterprises Inc.\", by letters patent dated September 27,1957, by supplementary letters patent dated April 17, 1958, changing the said original name to .that of \"Kirk & Lane Inc.\", changing its name once again to that of \"Donald Kirk Enterprises Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of January, 1959.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14336-58) , Eastern Townships Warehousing Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated fifteenth day of December 1958, to the company \"Eastern Townships Warehousing Ltd.\", 1) decreasing its capital by reducing the par value of the preferred shares from $100 to $10 each, and reducing the number of common shares from 3,000 to 500; 2) the amount with which the said company shall continue its operation to at least $7,500; 3) modifying the provisions of the former letters patent respecting the privileges attached to the pieferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13581-58) E.J.Chartier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eleventh day of December, 1958, to the company \"E.J.Chartier Inc.\", amending the provisions of its supplementary letters patent of October 22, 1958 in that which concerns the rights, privileges and restrictions attached to the preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10445-57) Entreprises Beaubien Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated thirty-first day of December, 1958, to the company \"Entreprises Beaubien Inc.\", increasing its capital stock from $10,000 to $200,000, the additional capital stock being divided into 31,000 common shares of $5 each, 5,000 preferred class \"A\", of 85 each, and into 2,000 preferred shares, class \"B\", of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 773 (P.G.14543-58) Fiber-Plast Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix décembre 1958, à la compagnie \"Antitheimo Products Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 17 novembre 1952, changeant son nom en celui de \"Fiber-Plast Company Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1958.* v L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14517-58) Gaz National Inc.National Gas Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente et un décembre 1958, à la compagnie \"Gaz National Inc.\u2014 National Gas Ino»\", 1) convertissant ses 400 actions sans valeur nominale ou au pair en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune; 2) refondant ces 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune; 3) augmentant son capital de $2,000 à $500,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 49.800 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14158-58) Gotham Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente décembre 1958, à la compagnie \"Sano Linen Service Corporation\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 3 septembre 1958, changeant son nom en celui de \"Gotham Investment Corporation\".Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o \u2022 \u2022 P.FRENETTE.(P.G.10009-59) Henry Horky Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, d a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du tieize janvier 1959, à la compagnie \"Marvel Food Packers Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première Krtie de la Loi des compagnies de Québec par très patentes du 4 juillet 1950, changeant son nom en celui de \"Henry Horky Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(A.G.14543-58) Fiber-Plast Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the' Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of December, 1958, to the company \"Antithermo Products Ltd.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of November 17, 1952, changing its name into that of \"Fiber-Plast Company Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14517-58) Gaz National Inc.National Gas Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated thirty-first day of December, 1958, to the company \"Gaz National Inc.\u2014 National Gas Inc.\", 1) converting its 400 shares without nominal or no par value into 400 common shares of a par value of $5 each; 2) converting these 400 common shares of' a par value of $5 each into 200 common shares of a par value of $10 each; 3) increasing its capital stock from $2,000 to $500,000, the additional capital stock being divided into 49,800 common shares of a par value of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14158-58) \" Gotham Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of December, 1958, to the company \"Sano Linen Service Corporation\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of September 3, 1958, changing its name into that of \"Gotham Investment Corporation\".Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10009-59) _ Henry Horky Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirteenth day of January 1959, to the company \"Marvel Food Packers Ltd.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated July 4, 1950.chaining its name to that of \"Henry Horky Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1959.v P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General. 774 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Toms 91, JV° 7 (P.G.14807-58) Holt, Renfrew- & Co., Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-huit décembre 1958, à la compagnie \"Holt, Renfrew & Co., Limited\", 1) réduisant son capital de $2,000,000 à $1,500,-000, la valeur au pair des actions ordinaires étant réduite de $100 à $50; 2) augmentant le capital ainsi réduit de $1,500,000 à $2,000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 10,000 actions ordinaires de $50 chacune; 3) subdivisant les 20,000 actions ordinaires de $50 chacune en 200,000 actions ordinaires de $5 chacune; 4) modifiant et étendant les dispositions des lettres patentes de la compagnie.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14946-58) Hygrade Food Products Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première -partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-huit décembre 1958, à la compagnie \"Hygrade Food Products Incorporated\", 1) subdivisant ses 100 actions ordinaires de $100 chacune en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune; 2) convertissant ces 10,000 actions ordinaires de $1 chacune en 5,000 actions, classe \"A\", de $1 chacune et en 5,000 actions, classe \"B\", de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14623-58) Lachine Remnant Store Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze décembre 1958, à la compagnie \"Lachine Remnant Store Ltd.\", augmentant son capital de $20,000 à $60,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14517-58) Lasnier & Galipcau Limitée Lasnier & Galipeau Limited Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix décembre 1958, à la compagnie \"Lasnier & Galipeau Limitée \u2014 Lasnier & Galipeau Limited\", augmentant son capital de $149,900 à $299,900, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 actions privilégiées de $100 chacune.(A.G.14807-58) Holt, Renfrew & Co., Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eighteenth day of December, 1958, to the company \"Holt Renfrew & Co;, Limited\", 1) reducing its capital stock from $2,000,000 to $1,500,-000, the par value of the common shares being reduced from $100 ro $50 each; 2) increasing the capital stock thus reduced from $1,500,000 to $2,000,000, the additional capital stock being divided into.10,000 common shares of $50 each; 3) subdividing the 20,000 common shares of $50 each into 200,000 common shares of $5 each; 4) amending and extending the provisions of letters patent of the company.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14946-58) Hygrade Food Products Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eighteenth day of December, 1958, to the company \"Hygrade Food Products Incorporated\", 1) subdividing its 100 common shares of $100 each into 10,000 common shares of $1 each; 2) converting its 10,000 common shares of $1 each into 5,000 shares, class \"A\" of $1 each and into 5,000 shares, class \"B\", of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14623-58) - Lachine Remnant Store Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eleventh day of December, 1958, to the company \"Lachine Remnant Store Ltd.\", increasing its capital stock from $20,000 to $60,000, the additional capital stock being divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14517-58) Lasnier & Galipeau Limitée Lasnier & Galipeau Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of December, 1958, to the company \"Lasnier & Galipeau Limitée \u2014 Lasnier & Galipeau Limited\", increasing its capital stock from $149,900 to $299\"900, the additional capital stock being divided into 1,500 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1959, Vol.91, No.7 775 Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, dut décembre 1958.this tenth day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE 49851-a P.FRENETTE.49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14969-58) Les Agences Grenache Inc.Grenache Agencies Inc.(A.G.14969-58) Les Agences Grenache Inc.__Grenache Agencies Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent have been issued by the Lieutenant-province de Québec des lettres patentes supplé- Governor of the Province of Quebec, dated the mentaires, en date du dix-neuf décembre 1958, nineteenth day of December, 1958, to the com-à la compagnie \"Les^Agences Grenache Inc.\u2014 pany \"Les Agences Grenache Lie.\u2014 Grenache Grenache Agencies Inc.\", augmentant son capital Agencies Inc.\", increasing its capital stock from de 920,000 à $100,000, le capital-actions addition- $20,000 to $100,000, the additional capital stock nel étant divisé en 8,000 actions privilégiées de being divided into 8,000 preferred shares of $10 $10 chacune.each.Daté du bureau du Procureur général, le dix- Dated at the office of the Attorney General, neuf décembre 1958.this nineteenth daj of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49851-0 P.FRENETTE.-49851 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14693-58) - Les Industries de la Rive Sud, Ltée South Shore Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé -par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze décembre 1958, à la compagnie \"Les Industries de la Rive Sud, Ltée \u2014 South Shore Industries Ltd.\", réduisant son capital de $20,000 à $10,000, le capital-actions annulé étant divisé en 200 actions privilégiées de $50 chacune; 2) augmentant son capital ainsi réduit de $10,000 à $75,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 300 actions ordinaires de $50 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $50 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre-1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14548-58) Les Meubles de St-Barthélemy, Ltée St-Barthélemy Furniture Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix décembre 1958, à la compagnie \"Les Meubles de St-Baithélemy, Ltée \u2014 St-Barthélemy Furniture Ltd.\", augmentant son capital de $75,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14697-58) Litho Plate Making Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze janvier 1959, à la compagnie \"Office Sales & Service Co.Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de (A.G.14693-58) Les Industries de la Rive Sud, Ltée South Shore Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twelfth day of December 1958, to the company \"Les Industries de la Rive Sud, Ltée \u2014 South Shore Industries Ltd.\", decreasing its capital stock from the sum of $20,000 to $10,000, the cancelled share capital being divided into 200 preferred shares of $50 each; 2) increasing its share capital thus decreased from $10,000 to.$75,000, the additional share capital being divided into 300 common shares of $50 each and 1,000 preferred shares of $50 each.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14548-58) Les Meubles de St-Barthélemy, Ltée St-Barthélemy Furniture Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of December, 1958, To the company \"Les Meubles de St-Barthélemy, Ltée \u2014 St-Barthélemy Furniture Ltd.\", increasing its capital stock from $75,000 to $100,000, the additional capital stock being divided into 250 common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney \"General, this tenth day of December, 1958.P.FRENETTE, \" 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14697-58) Litho Plate Making Ltd.Notice is hereby-given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fourteenth day of January, 1959, to the company \"Office Sales & Services Co.Inc.\", constituted as a corporation under-said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated 776 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7 Québec par lettres patentes du 4 février 1953, changeant son nom en celui de \"Litho Plate Making Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le quatroze janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14093-58) McNeil Transport Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois décembre 1958, à la compagnie \"McNeil Transport - Limited\", 1) réduisant son capital de $20,000 à $7,200, le capital-actions annulé étant divisé en 128 actions' ordinaires de $100 chacune; 2) subdivisant et changeant ses 72 actions ordinaires restantes de $100 chacune en 1,440 actions ordinaires sans valeur au pair; 3) augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé.en 8.5C0 actions ordinaires sans valeur au pair et en 40,000 actions privilégiées de $10 chacune; 4) fixant le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations à non moins de $90,000.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14832-58) Milano Furniture Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu trente décembre 1958, à la compagnie \"Milano Furniture Inc.\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau «lu Procureur généra), le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14827-58) Mount Royal Property Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux décembre 1958, à la compagnie \"Mount Royal Property Corporation\", 1) réduisant son capital de $200,000 à $120,000, le capital-actions annulé étant divisé en 80,000 actions privilégiées de $1 chacune; 2) augmentant son capital ainsi réduit de $120,-000 à $200,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 80,000 actions privilégiées de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14625-58) \\ Nsu Prinz of Canada Ltd.Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplé- February 4, 1953, changing its name to that of \"Litho Plate Making Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14093-58) McNeil Transport Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-third day of December, 1958, to the company \"McNeil Transport Limited\", 1) decreasing its capital from the sum of $20,000 to $7,200, the cancelled share capital being divided into 128 common shares of $100 each; 2) subdividing and changing its 72 remaining common shares of $100 each into 1,440 common shares without par value; 3) increasing its capital the additional share capital being divided into 8,560 common shares without par value and 40,000 preferred shares of $10 each; 4) fixing the amount with which the said company shall continue its operations at not less than $90,000.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14832-58) Milano Furniture Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of December, 1958, to the company \"Milano Furniture Inc.\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14827-58) Mount Royal Property Corporation Notice is hereby given that under Part of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December twenty-second, 1958, to the company \"Mount Royal Property Corporation\", 1) reducing its capital stock from $200,000 to $120,000, the cancelled capital stock being divided into 80,060 preferred shares of $1 each; 2) increasing its capital stock thus reduced from $120,000 to $200,000, the additional capital stock being divided into 80,000 preferred shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14625-58) Nsu Prinz of Canada Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the ele- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Uth, 1969, Vol.91, No.7 777 men ta ires,.en date du onze décembre 1058, à la compagnie \"Papineau-Gilford Motors Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 15 décembre 1955, changeant son nom en celui de \"Nsu Prinz of Canada Ltd.\", Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14674-58) Peel-Windsor Garage Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux décembre 1958, à la compagnie \"Peel-YVindsor Garage Incorporated\", 1) augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé en 10 actions sans valeur au pair ou nominale; 2) fixant le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations à non moins de $80,000.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assist un t-piocureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14522-58) Pulp Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze décembre 1958.à la compagnie \"Pulp Associates* Inc.\", augmentant son capital de $1,000 à $41,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14067-58) Quebec Motel Association Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit janvier 1959, à la corporation \"Quebec Motel Association Inc.\", constituée par lettres patentes en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi, étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.11901-58) Seaway Supply Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du seize décembre 1958, à la compagnie \"Seaway Lumber Corporation\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentez du 10 juin 1958, changeant son nom en celui de \"Seaway Supply Corporation\".venth day of December 1958, to the company \"Papineau-Gilford Motors Ltd.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies of Quebec, by letters patent dated December 15, 1955, chaing its name to that of \"Nsu Prinz of Canada Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December 1958, P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14674-58) Peel-Windsor Garage Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-second day of December 1958, to the company \"Peel-Windsor Garage Incorporated\", 1) increasing its capital, the additional share capital being divided into 10 shares without nominal or par value; 2) fixing the amount with which the said company shall continue its operations at not less than $80,000.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14522-58) Pulp Associates Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eleventh day of December, 1958, to the com-panv \"Pulp Associates Inc.\", increasing its capital from the sum of $1,000 to $41,000, the additional share capital being divided into 400 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14067-58) Quebec Motel Association Inc.Notice is hereby, given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eighth day of January.1959, to the corporation \"Quebec Motel Association Inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part III of the said Act, extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11901-58) Seaway Supply Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the sixteenth day of December, 1958, to the company \"Seaway Lumber Corporation\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated June 10, 1958, changing its name into that of \"Seaway Supply Corporation\". 778 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1959, Tome 91, N9 7 Daté du bureau du Procureur général, seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.(P.G.14948-58) Stern thai Dress Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux décembre 1958, à la compagnie \"Sternthal Dress Company\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.* L'Assistant-procureur général suppléant, .49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14721-58) Typographie Service Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept décembre 1958, à la compagnie \"Typographie Service Company Limited, 1) réduisant son capital de $150,000 à $30,000, le capital-actions annulé étant divisé en 2,250 actions privilégiées, classe \"B\", de $10 chacune et en 9,750 actions privilégiées classe \"A\", de $10 chacune; 2) augmentant son capital ainsi réduit de $30,000 à $250,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 2,250 actions privilégiées, classe \"B\", de $10 chacune et en 19,750 actions privilégiées, classe \"A\" de $10 chacune.- Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-0 P.FRENETTE.(P.G.14947-58) Venus Restaurants Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois décembre 1958, à la compagnie \"Venus Restaurants Incorporated\", 1) réduisant son capital de $20,000 à $7,000, le capital-actions annulé étant divisé en 130 actions ordinaires de $100 chacune; 2) augmentant son capital ainsi réduit de $7,000 à $107,-000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49851-o P.FRENETTE.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTD7 Numéro 85 Québec, le 4 février 1959.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une convention collective de travail relative aux distributeurs de pain dans la région de Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14948-58) Sternthal Dress Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-second day of December 1958, to the company \"Sternthal Dress Company\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14721-58) Typographic Service Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the seventeenth day of December, 1958, to the company \"Typographic Service Company Limited\", 1) reducing its capital stock from $150,000 to $30,000, the cancelled capital stock being divided into 2,250 preferred shares, class \"B\", of $10 each and into 9,750 preferres shares, class \"A\", of $10 each; 2) increasing its capital stock thus reduced from $30,000 to $250,000, the additional capital stock being divided into 2,250 preferred shares, class \"B\", of $10 each and into 19,750, preferred shares, class \"A\" of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14947-58) Venus Restaurants Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-third day of December 1958, to the company \"Venus Restaurants Incorporated\", 1) decreasing its capital from the sum of $20,000 to $7,000, the cancelled share capital being divided into 130 common shares of $100 each; increasing its capital thus decreased from $7,000 to $107,000, the additional share capital being divided into 1,000 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49851 Acting Deputy Attorney General.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 85 Quebec, February 4, 1959.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a collective labour agreement relating to bread distributors in the region of Montreal.* . QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Uth, 1969, Vol.91, No.7 779 Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de- la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amen-dements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: L'Association des Boulangers de Montréal; Christie's Bread Ltd.; Pain Suprême Ltée.; Et, d'autre part: L'Union des Vendeurs de Produits Alimentaires, Vendeurs à Commission, Employés de Laiterie et de Crème Glacée, local 973, affiliée à la Fraternité Internationale des Conducteurs d'Attelage, Chauffeurs, Hommes d'Entrepôts et Aides d'Amérique (F.A.T.\u2014 C.Ô.I.); L'Union Internationale d'Amérique des Ouvriers de Boulangerie et de Confiserie, Local 55, affiliée au Congrès du Travail du Canada, Section des Chauffeurs et Vendeurs; pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 23 août 1958; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans l'industrie et les métiers visés et dans la juridiction territoriale indiqués dans ladite requête; Attendu que les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de ladite Loi avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 23 août 1958.L'Association Professionnelle des Boulangers de Québec (section de Montréal) est acceptée comme partie co-contractante de 1ère part.I.Définition: Pour les fins d'application, du décret, les mots et termes suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: o) Le mot \"employeur\" désigne toute personne, association, corporation, compagnie, propriétaire et/ou exploitant d'une boulangerie.b) Le mot \"employé\" désigne tous les livreurs, conducteurs et/ou chauffeurs employés par un employeur ou assigné au transport, à l'expédition, à la livraison des produits de boulangerie.c) Le terme \"produits de boulangerie\" désigne tout genre de pains, petits pains, produits sucrés à base de levure.DI.Juridiction territoriale: Le décret comprend l'Ile de Montréal, l'Ile Jésus, les villes de Préville, Montréal-Sud, Boucherville, Lemoyne, Mackay-ville et Greenfield Park et les cités de St-Lambert, Longueuil et Jacques-Cartier.III.Juridiction professionnelle: Le décret s'applique à tous les employeurs et employés ainsi qu'à tous les concessionnaires, représentants autorisés et/ou toutes autres personnes employées au transport, à l'expédition, à la livraison des produits de boulangerie, que ces produits soient fabriqués ou non à l'intérieur de la juridiction territoriale du décret, et pourvu que tels transport, expédition, livraison et ventes soient effectués en deçà de telle juridiction territoriale.- Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties nereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: Montreal Bakers' Association;, Christie's Bread Ltd.; \"Pain Suprême Ltée\"; And, on the other part: Food Drivers, Commission Salesmen, Dairy & Ice Cream Workers, Local 973, affiliated with the International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers of America (A.F.L.-C.I.O.) ; Bakery & Confectionery Workers' International Union of America, Local 55, affiliated with The Canadian Labour Congress, Drivers Salesmen Section; for the employers and the employees of the industry and trades concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of August 23, 1958; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance for the establishing of working conditions in the industry and trades concerned and in the territorial jurisdiction indicated in the said petition; Whereas the provisions of the Act have been duly observed as regards the publication of notices; Whereas the objections set forth have been duly considered, as required by the Act; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour; That the said petition be accepted in pursuance of the provisions of the said Act, with, however, the following new provisions to be substituted for the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of August 23, 1958.\"L'Association Professionnelle des Boulangers de Québec (section de Montréal)\" is accepted as co-contracting party of the first part.I.Definitions: For the purpose of enforcement of the decree, the following terms shall have the meaning hereafter given to them: a) The term \"employer\" means any person, association, corporation, company, owner and/or operator of a bakery.6) The term \"employee\" means all delivery men, drivers and/or chauffeurs employed by an employer or engaged in the t ran s j nutation, shipping, delivery of bakery products.c) The term \"bakery products\" means any type of bread, bread rolls, yeast raised sweet goods.H.Territorial jurisdiction: The decree shall apply to the Island of Montreal, Jesus Island, the towns of Preville, Montreal-South, Boucherville, Lemoyne, Mackayville and Greenfield Park and the cities of St-Lambert, Longueuil and Jacques-Cartier.HI.Professional jurisdiction: The decree shall apply to all employers and employees and to all jobbers, franchisee operators and/or any other persons employed in the transportation, snipping, delivery of bakery products, whether or not these products are manufactured within the territorial jurisdiction of the decree and provided such transportation, shipping, delivery and sales are made within such territorial jurisdiction. 780 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le décret ne s'applique pas au transport et/ou à l'expédition de produits de boulangerie à travers où en deçà de la juridiction territoriale du décret, pourvu que lesdits produits de boulangerie soient en transit ou destinés à tout autre endroit qu'à un établissement de vente au détail.IV.Salaires et/ou commissions: Tout employé doit recevoir un salaire minimum de $40.00 pour une semaine de travail de cinq (5) jours.\"\"V.Heures de travail: La semaine régulière de travail est de cinq (5) jours et aucune livraison ne doit être faite le dimanche et le mercredi.Dans toute semaine au cours de laquelle il y a un jour de fête chômé qui ne tombe pas le mercredi, ledit mercredi devient une journée régulière de travail.VI.Jours chômés: Les jours suivants sont chômés: Le Premier jour de l'An, le 2 janvier, le Lundi de Pâques, la fête de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, le 1er juillet (Confédération), la fête du Travail, Noël et le 26 décembre.VH.Vacances payées: Tout employé doit recevoir, à titre de rémunération de vacances, un minimum de 2% de son salaire lorsqu'il a complété douze (12) mois de service chez un employeur.VIII.Durée du décret: Le décret est valable le jour de sa publication dans la Gazette officielle de de Québec et demeure en vigueur pour une période d'une (1) année.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant la date de son expiration.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.L.DÉSDLETS, 49852-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÊCUTD7 \u2022 ____ Numéro 86 Section \"A\" Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, the decree shall- not apply to the transportation and/or shipping, of bakery products through or within the territorial jurisdiction of this decree, provided that the said bakery products are in transit or destined to any place other than a retail outlet.TV.Wages, and/or Commission: Every employee shall receive a guaranteed minimum of $40.00 fora five (5) day work week.V.Hours of work: The normal woik week shall consit of five (5) days and there shall be no delivery on Sunday and Wednesday.In any week in which a holiday occurs other than on a Wednesday, the Wednesday shall become a regular working day.VI.Holidays: The following days shall be kept as holidays: New Year's Day, January 2, Easter Monday, the Queen's Birthday, St-Jean-Baptiste Day, Confederation Day (July 1st) Labour day, Christmas Day and December 26.VII.Vacation with pay: Every employee shall receive, as vacation pay, a minimum of 2% of his earnings after completing twelve (12) months service with an employer.VIII.\" Duration of the decree: The decree shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remain in force for a period of one year.It will then renew itself automatically from year to year, unless \u2022 either one of the contracting parties notified the other party, in writing, to the contrary within the period extending from the sixtieth to the thirtieth day before the date of its expiration.Such a notice must also be filed with the Minister of Laboui.L.DÊSDLETS, 49852-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER \u2022 Number 86.Part \"A\" Québec, le 4 février Ï959.Quebec, February 4, 1959.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments to the decree relating à l'industrie de la chapellerie pour hommes et to the men's and boy's hat and cap industry garçons dans la province de Québec.in the province of Quebec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 385 du 19 avril 1956 amendé par l'arrêté en conseil numéro 100-B du 31 janvier 1957, ont présenté au Ministre du travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 27 décembre 1958; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the men's and boys' hat and cap industry in the province of Quebec, rendered obligatory by the decree No.385 of April 19, 1956, as amended by Order in Council No.100-B of January 31, 1957, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Whereas the petition has been published in the issue of December 27, 1958; of the Quebec Official Gazette.Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; \\ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 781 Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 385, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"o\" de l'article V est remplacé par le suivant: \"V.Taux minima: a) Les taux horaires et hebdomadaires minima suivants doivent être payés aux salariés compétents dans les classifications ci-dessous mentionnées, à compter du 1er janvier 1959: Salaire Salaire Métiers: horaire hebdo- madaire Coupeur. 1.Paragraph \"o\" of article V is replaced by the following: \"V.Minimum wages: a) The minimum hourly and weekly, wage rates shall be the following for skilled workers in the classifications hereinafter mentioned, from January 1st 1959.Classifications: Hourly Weekly rates wages Cutter.$1.30 / $52.00 Operator.1.03- 41.20 Blocker.1.17^ 47.00 Lining maker.0.74 29.60 Hand finisher.0.65 26.00 General worker.0.58^ 23.40 A compter du 1er juillet 1959, les taux minima Beginning as and from July 1st, 1959, the seront les suivants: minimum wages shall be as follows: Métiers: Salaire Salaire horaire hebdomadaire Classifications: Hourly Weekly rates wages Cqupeur.$1.35 Opérateur.1.08 Bloqueur.1.22^ Faiseur de doublu re.0.79 Finisseur à la main.0.70 Employé général.0.63^ $54.00 43.20 49.00 31.60 28.00 Cutter.$1.35 Operator.1.08 Blocker.1.22^ Lining maker.0.79 Hand finisher.0.70 25.40\" General worker.0.63^ $45.00 43.20 49.00 31.60 28.00 25.40\" 2° L'article VII est remplacé par le suivant: \"VII.Jours' de fi'te statutaires et religieuses: Les employeurs doivent donner à leurs salariés sept (7) jours de fêtes payés, à savoir: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la fête de la Reine, la Confédération, la fête du Travail et le jour de Noël.On peut remplacer l'une de ces fêtes par la Saint-Jean-Baptiste.Si l'employeur ferme ses portes un ou des jours de fête religieuse de sa foi, les salariés doivent être payés pour ce ou ces jours au lieu-de la fête de la Reine et de la Confédération.2.Article VII is replaced by the following: \"Vn.Legal and religious holiday with pay: Every employer shall give his employees seven (7) holidays with pay, namely: New Year's Day, Good Friday, Ascension Day, Queen's Birthday, Confederation Day, Labour Day, Christmas Day.One of the above holidays may be replaced by St.John the Baptist Day.Should an employer close his establishment on a religious day or days of his faith, the employees shall be paid for such day or days in place of the Queen's Birthday and Confederation Day.Tout travail exécuté ces jours-là doit être Work performed on these days by any em-rémunéré à raison de salaire double.ployee shall be paid at the rate of double time.Tout salarié qui s'absente une journée complete pendant une semaine de travail où tombe une des fêtes ci-haut mentionnées n'a droit qu'à 75% de la rémunération accordés pour telle fete.Tout salarié qui s'absente deux journées complètes pendant une semaine de travail où tombe une «les fêtes ci-haut mentionnées n'a droit qu'à 50% de la rémunération accordée pour telle fête.Tout salarié qui s'absente plus de deux (2) jours pendant une semaine de travail où tombe une des fêtes ci-haut mentionnées n'a droit à aucune rémunération pour telle fête.Toutefois, pour les fins de cet article, une suspension par l'employeur ou une absence causée par la maladie n'est pas considérée comme une ubsence.\" 3° lie taux de trois pour cent (3%) apparaissant dans le titre et dans plusieurs paragraphes de l'article IX est porté à trois et demi pour cent L.DÊSILETS, 49852-0 Greffier du Conseil Exécutif.Any employee who is absent for one full day during a work week in which any of the aforesaid holidays fall shall be entit Iedxto only 75% of the pay granted for such holiday.Any employee who is absent for two (2) full days during a work week in which any of the aforesaid holidays fall shall be entitled to only 50% of the pay granted for such holiday.Any employee who is absent for more than two (2) days during any work week in which any of the aforesaid holidays fall, shall not be paid for such holiday.However, any lay-off by the employer and any absence caused by sickness shall not be deemed to be absences of the article.\" 3.The rate of three per cent (3%) appearing in the title and in many paragraphs of article IX are replaced by the rate of three and one half per cent (3^%).ttt,^ L.DÊSILETS, 49852-0 Clerk of the Executive Council. t 782 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91,~N° 7 Avis est par les présentes donné que la corpo- Notice is hereby given that the municipal cor-ration municipale du village de Pointe-Gatineau poration of the village of Pointe-Gatineau will adressera une requête à l'honorable Lieutenant- present a petition to the Honourable the Lieute-gouverneur en conseil, demandant l'érection de nant-Governor in Council, requesting the erection son territoire en municipalité de ville.Le nom of its territory into a- town municipality.The de la municipalité projeté de ville sera le suivant: name of the projected municipality will be the \"La corporation municipale de la ville de Pointe- following: \"The Municipal Corporation of the Gatineau\".Le territoire de la municipalité com- Town of Pointe-Gatineau\".The territory of the prendra tout le territoire situé dans les limites municipality will be comprised of all the territory suivantes et décrit comme suit: \"Un certain ter- situated within the following limits and describ-rain de forme irrégulière, comprenant tous les ed as follows: \"A certain lot of land of irregular lots inclus dans les cadres du village'actuel de form, comprising all the lots included within the Pointe-Gatineau, comté de Hull et étant partie limits of the present village of Pointe-Gatineau, du cadastre du village de Pointe-Gatineau, county of Hull and being part of the cadaster of division d'enregistrement de Hull, province de the village of Pointe-Gatineau, registration divi-Québec et pour être décrit comme suit: ' s ion of Hull, province of Quebec and to be des- cribed as follows: Commençant d'un point appelé \"A\", étant.Starting at a point called \"A\", being situated situé à l'intersection de la limite nord de la route at the intersection of the northern limit of the de la Savane et étant la ligne de division des lots route of the Savane, and being the dividing line 585 et 28, cadastre du village de Pointe-Gatineau of lots 585 and 28, cadaster of the village of .avec la ligne extérieure Est du canton de Hull Pointe-Gatineau with the outwide eastern line (limites de la ville).of the township of Hull (limits of the town).Du point \"A\", mesuré dans une direction est, From point \"A\", measured in an eastern direc-sur une distance de dix-sept mille deux cents-pieds tion, along a distance of seventeen thousand two (17,2000 plus ou moins, en suivant la limite nord hundred feet (17,2000 more or less, by following et le route de la Savane jusqu'au point \"B\", the northern limit of the route of the Savane to étant situé à l'intersection des lignes sud du lot point \"B\", being situated at the intersection of 42, ouest des lots 43 et 50 et nord du lot 504 the southern lines of lot 42, west of lots 43 and (Route de la Savane), tous ces lots étant du 50 and north of lot 564 (Route of the Savane), cadastre du village de Pointe-Gatineau.all these lots being of the cadaster of the village of Pointe-Gatineau.Du point \"B\", mesuré dans une direction sud, From point \"B\", measured in a southern di-sur une distance de trois mille cent vingt-deux rection, along a distance of three thousand one (3,1220 plus ou moins jusqu'au point \"C\", en hundred and twenty-two (3,122') feet more or suivant la ligne est des lots 58-2, 58-1, 546-25, less to point \"C\", by following the east line of 547-8, 547 n.s., 548, 540, 553, cadastre du village lots 58-2, 58-1, 546-25, 547-8, 547 n.s., 548, 549, de Pointe-Gatineau, jusqu'à son intersection avec 553 cadastre of the village of Pointe-Gatineau, la ligne des hautes-eaux de la rive nord de la to its intersection with the high water-line of the Rivière Ottawa.north bank of the Ottawa River.Du point \"C\", dans une direction générale From point \"C\", in a general southwesterly sud-ouest, en suivant la ligne des hautes-eaux direction, by following the line of high water of de la Rivière Ottawa, puis dans une direction the Ottawa River, then in a northwesterly direc-nord-ouest en suivant la ligne des hautes-eaux tion by following the high water line on the sur la rivenord-est de la rivière Gatineau jusqu'au northeast bank of the Gatineau River to point point \"D\", lequel point est situé à l'extrémité \"D\", which point is situated at the extreme south sud de la ligne separative du canton de Hull avec of the dividing line of the townhsip of Hull, with la rue St-Jean Baptiste.St-Jean-Baptiste Street.Du point \"D\", mesuré dans une direction nord, From point \"D\", measured in a northern sur une distance de cinq mille quatre cent vingt direction, along a distance of five thousand four pieds (5,4200 plus ou moins en suivant la limite hundred and twenty-fcet (5,4200 more or less ouest de la rue St-Jean Baptiste et des lots by following the west limit of St-Jean Baptiste 116, 115-1, 115-2, 115-3, 115-4, 115-5, 115-6, street and of lots 116, 115-1, 115-2, 115-3, 577-12, 577-41 (rue), 577-13, 577-23, 577-42 115-4, 115-5, 115-6, 577-12, 577-41 (street), (rue), 577-100 et 577-160 (rue Laurin) 677 et 577-13, 577-23, 577-42 (street), 577-100 and 577-578 n.s., cadastre du village de Pointe-Gatineau, 160 (Laurin Street) 577 and 578 n.s., cadaster of jusqu'au point \"A\", point de commencement.the village of Pointe-Gatineau, to point \"A\", starting point.Ledit terrain peut être plus particulièrement The said lot of land may be more particularly décrit comme suit: described as follows: Borné vers le nord par les lots 28, partie des Bounded on the north by lots 28, part of lots lots 30, 31, 32, (Chemin Brûlé) 33, 34, 35,36, 37, 30,31,32, (Road Brûlé) 33,34, 35, 36,37, 38, 39, 38, 39, 40, 41, et 42; vers l'est par les lots 50 et 40, 41 and 42; on the east by lots 50 and 51 and 51 et 57; vers le sud par les rivières Ottawa et 57; on the south by the Ottawa and Gatineau Gatineau; vers l'ouest par une partie du canton Rivers; on the west, by a part of the township of de Hull.Hull.A cette fin un recensement avait été ordonné For this purpose a census was ordered by the par le conseil et la population se chiffre à 6,648 council and the population counts 6,648 souls as âmes en date du 16 décembre 1957.from December 16, 1957.La municipalité de la ville de Pointe-Gatineau The municipality of the town of Pointe-Gati-sera érigée en ville sous l'empire de la loi des cités neau shall be erected into a town under the empire et villes.of the Cities and Towns Act.Avis divers Miscellaneous Notices QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February l#h, 1959, Vol.91, No.7 783 Signé à Pointe-Gatineau, district de Hull, province de Québec, ce 19e, jour de janvier 1959.(Signé) Le Maire, DANIEL LAFORTUNE.Le Secrétaire-trésorier, 49724-4-4-c LOUIS LAMARCHE.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM Compagnie Équitable d'Assurance contre le feu (capital mutuel) Equitable Fire Insurance Company (stock mutual) Avis est par les présentes donné que le Lieutenant-gouverneur en conseil, par l'arrêté numéro 44, sanctionné le 29 janvier 1959, a changé, en conformité des dispositions de l'article 93 de la Loi des assurances de Québec, le nom de la \"Com- Êagnie Équitable d'Assurance contre le feu \u2014 équitable Fire Insurance Company\" en celui de \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales\" et, en anglais, en celui de \"The Equitable General Insurance Company\", à compter du 29 janvier 1959.Donné à Montréal, le 4 février 1959.Le Secrétaire-trésorier, 49854-o J.J.MDLORD.Don-Mar Realty Limited Sommaire du règlement \"C\" _ Qu'il soit et il est décrété et adopté: Qu'après paiement de ou provision suffisante pour toutes dettes et obligations, les biens de cette compagnie soient distribués proportionnellement aux actionnaires selon leurs droits respectifs.Le règlement \"C\" a été adopté par le bureau de direction de la compagnie à une assemblée dûment convoquée et tenue, mardi, le 3 février 1959.Certifié à Montréal, ce 5e jour de février 1959.(Sceau) Le Secrétaire-adjoint, 49866-0 E.G.EVANS.(P.G.10087-58) Beauty Homes Inc.Règlement N° h \"1° Le nombre des directeurs de la compagnie est par les présentes augmenté de trois directeurs à quatre directeurs de sorte que le bureau des directeurs se composera dorénavant de quatre directeurs; 2° Trois directeurs constitueront un quorum à toute assemblée du bureau des directeurs; 3° Tout règlement ou résolution de la compagnie incompatible avec le présent règlement, sont par les présentes amendés, modifiés ou revisés afin de donner effet au présent règlement.\" Copie certifiée du règlement N° 4 dûment adopté à une assemblée des directeurs tenue le sixième jour d'octobre 1958, et approuvé à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le sixième jour d'octobre 1958, par les actionnaires détenant entre eux (100%) des actions représentées à cette assemblée.Le Secrétaire, 49874-0 ROLAND JULIEN.Signed at Pointe-Gatineau, district of HulL Province of Quebec, this 19th day of January.1959.' (Signed) DANIEL LAFORTUNE, Mayor.LOUIS LAMARCHE, 49724-4-4 Secretary-Treasurer.NOTICE OF CHANGE OF NAME Equitable Fire Insurance Company (stock mutual) Compagnie Équitable d'Assurance contre le feu (capital mutuel) Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in council, by the order Number 44, assented to the 29th of January 1959, has changed, in accordance with the provisions of section 93 of the Quebec Insurance Act, the name of the \"Equitable Fire Insurance Company \u2014 Compagnie Équitable d'Assurance contre le feu\", to that of \"The Equitable General Insurance Company\" and, in French, to that of \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales\", as from the 29th of January 1959.Given in Montreal, on the 4th of February 1959.J.J.MILORD, 49854-o Secretary-Treasurer.Don-Mar Realty Limited Summary of by-law \"C\" Be it and it is hereby made, passed and enacted: That, after payment of or adequate provision for all liabilities, debts or obligations, this Company's assets be distributed ratably amongst its shareholders in accordance with their respective rights.By-law \"C\" was enacted by the^ Board of Directors of the Company at a meeting thereof duly called and held on Tuesday, the 3rd day of February, 1959.Certified at Montreal, this 5th day of February, 1959.(Seal) E.G.EVANS, 49866-0 Assistant-Secretary.(A.G.10087-58) Beauty Homes Inc.By-law No.4 \"1.The number of directors of the company is hereby increased from three directors to four directors in order that the Board of Directors be hereafter composed of four directors; 2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors; 3.Any by-law or resolution of the company inconsistent with the present by-law, is hereby amended, modified or revised in order to give effect to this by-law.\" Certified copy of by-law No.4 duly adopted at a meeting of directors held the sixth day of October, 1958, and confirmed at a special general meeting of the company held the sixth day of October, 1958 by the shareholders holding among themselves (100%) of the shares represented at said meeting.ROLAND JULLEN, 49874 Secretary. 784 ' GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, lj février 1959, Tome 91, N9 7 Ville de Nicolet Avis est par les présentes donné que, par arrêté , ministériel, et conformément aux dispositions de la Loi des Cités et Villes, (article 173a), il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, en date du 29 janvier 1959, d'approuver le règlement numéro 177, adopte par le Conseil Municipal de la ville de Nicolet, décrétant qu'à l'avenir la durée des fonctions du maire et des éclievins sera de trois ans.Nicolet, le 3 février 1959.' Le Greffier de la ville de Nicolet, 49870-o ARMAND PROULX.(P.G.12379-57) Lakeshore Unitarian Church Règlement N° 8 \"Qu'il soit décrété comme un règlement de \"Lakeshore Unitarian Church\", ce qui suit: 1.Le nombie des directeurs de la Corporation augmenté de huit (8) à dix (10).\" Je certifie que le précédent est une copie véritable d'un règlement décrété par lçs_ directeurs de \"Lakeshore Unitarian Church\", le 6 août 1958 et approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres de ladite Église présente à une assemblée généiale spéciale dûment convoquée aux fins de considérer ledit règlement et tenue le 21e jour de septembre 1958.(Sceau) Le Secrétaire, 49871 M.WOOLEY.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Les Producteurs de Meubles de Plessisvillc, Inc.\", en date du 22 janvier 1959, dont le siège social est situé à Plcssisville, comté de Mégantic, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le deux février 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 49872-o JEAN BRUCHÉSI.Règlement N° 15 Les biens de la compagnie seront distribués entre ses actionsnaires proportionnellement au montant des actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication de ce règlement dans la Gazette officielle de Québec.Copie certifiée du règlement N° 15 de la com-' pagnie \"La Compagnie Minière des Agrégats Légers du Québec (Libre de Responsabilité Personnelle) \u2014 The Quebec Lightweight Aggregates Mining Corporation (No Personal Liability) \" adopté par les directeurs à une assemblée tenue le 30 janvier 1959.Signé à Montréal, ce 7c jour de février 1959.Le Secrétaire, 49875-0 PAUL LEBEL.Avis est, par les présentes, domié que l'Honorable Secrétaire de la province a dûment reçu la troisième copie de la déclaration originale de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"St.Aloysius Parish Credit Union\", en date du 22 janvier 1959, dont le siège social est à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que Town of Nicolet Notice is hereby given that, by Order in Council, and pursuant to the provisions of the Cities and Towns Act, (section 173a), the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, under date of January 29, 1959, to approve bylaw number 177, adopted by the Municipal Council of the town of Nicolet, enacting that in future, the duration of the functions of the Mayor and Alderment shall be of three years.Nicolet, February 3, 1959.ARMAND PROULX, 49870 Clerk for the town of Nicolet.(A.G.12379-57) Lakeshore Unitarian Church \"By-law No.8 \"Be it enacted as a by-law of \"Lakeshore Unitarian Church\" as follows: 1.The number of the directors of the corporation is increased from eight (8) to ten (10).' I certify that the foregoing is a true copy of a by-law enacted by the directors of \"Lakeshore Unitarian Church\" on the 6th of August 1958 and approved by the vote of at least two-thirds of the membeis of the said church present at a special general meeting duly called for the purpose of considering the said by-law and held on the 21st day of September 1958.(Seal) M.WOOLEY.49871-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Les Producteurs de Meubles de Plessisville, Inc.\", under date of January 22nd, 1959, whereof the head office is at Plessisvillc, county of Megantic, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this second day of February, 1959.JEAN BRUCHÉSI, 49872 Under Secretary of the Province.By-Law No.15 The assets of the company shall be distributed amongst its shareholders proportionately to the amount of shares which they hold in the company, fifteen days after the publication of this bylaw in the Quebec Official Gazette.Certified copy of by-law No.15 of the company \"La Compagnie Minière des Agrégats Légers du Québec (Libre de Responsabilité Personnelle) \u2014 The Quebec Lightweight Aggregates Mining Corporation (No Personal Liability)\" adopted by the Directors at â meeting held on January 30,1959.Signed at Montreal, this 7th day of February, 1959.PAUL LEBEL, 49875 Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"St.Aloysius Parish Credit Union\", under date of January 22nd, 1959, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Mon- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February nth, 1969, Vol.91, No.7 785 ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le deux février 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 49876 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.50669-53) Lachine Super Market Inc.Règlement N° 64 10 Que le nombre des directeurs de la compagnie soit, et il est, par les présentes, diminué de quatre à trois, deux d'entre eux formeront quorum.2° Que les règlements de la compagnie soient, et ils sont par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Je, le soussigné, secrétaire de \"Lachine Super Market Inc.\", certifie, par les présentes, que le précédent règlement N 54 a été décrété à une assemblée du bureau de direction de la compagnie, tenue au bureau de la compagnie à 1.30 p.m., le 30e jour de décembre 1953, et confirmée à l'unanimité par les actionnaires de la compagnie à une assemblée générale spéciale des actionnaires convoquée à cette fin, et tenue le même jour à 2.30 p.m.* Xe Secrétaire, 49878 BEN MORRIS.(P.G.10858-54) Avis est donné que, le neuf février 1959, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé le règlement N° 28 de la corporation \"Hôpital Jean-Talon\", tel qu'adopté à l'assemblée générale des membres tenue le 25 mai 1958, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le dix février 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 49889-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.4464-46) Édifice des Arts Graphiques, Limitée Graphic Arts Building Limited Règlement N° 16 Le nombre des directeurs de la compagnie \"Édifice des Arts Graphiques, Limitée \u2014 Graphie Arts Building Limited\" est changé de trois qu'il était auparavant à celui de quatre et le règlement N° 3 de la compagnie est modifié en conséquence.Copie certifiée du règlement N° 16' dûment adopté à une assemblée des directeurs tenue le 31ème jour d'octobre 1958, et approuvé à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le 31ème jour d'octobre 1958, par les actionnaires détenant entre eux (100%) des actions représentées à cette assemblée.Le Président, 49890-o .PD2RRE DES MARAIS.(P.G.13617-58) Standard Structural Steel Ltd.Règlement N° 80 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de quatre (4) à cinq (5).treal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this second day of February, 1959.JEAN BRUCHÉSI, 49876-o Under Secretary of the Province.(A.G.50669-53) Lachine Super Market Inc.By-Law No.64 1.The number of the Board of Directors of the Company be, and it is hereby decreased from four to three, two of whom shall form a quorum.2.The By-laws of the company be, and they are hereby amended to accord with the foregoing.I.the undersigned, Secretary of \"Lachine Super Market Inc.\", certify that the above By-law No.54 was enacted at a Meeting of the Board of Directors of the company, held at the Company's office at 1.30 p.m., on the 30th day of December, 1953, and unanimously confirmed by the Shareholders of the Company at a Special General Meeting of Shareholders called for that purpose, held on the same day at 2.30 p.m.BEN MORRIS, 49878-0 Secretary.(A.G.10858-54) Notice is hereby given that, on February ninth, 1959, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved by-law No.28 of the corporation \"Hôpital Jean-Talon\", as adopted at the general meeting of the members held on May 25, 1958, and such pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, February tenth, 1959.JEAN BRUCHÉSI, 49889 Under Secretary of the Province.(A.G.4464-46) Édifice des Arts Graphiques, Limitée Graphic Arts Building Limited By-Law No.16 The number of directors of the company \"Édifice des Arts Graphiques, Limitée \u2014 Graphic Arts Building Limited\" is changed from three, its former number, to that of four and Company's By-law No.3 is amended accordingly.Certified copy of By-law No.16 duly adopted at a meeting of directors held the 31st.day of October 1958, and confirmed at a special genera I meeting of the Company held the 31st.day of October 1958, by the shareholders holding among themselves (100 %) of the shares represented at said meeting.PIERRE DES MARAIS, 49890 President.(A.G.13617-58) Standard Structural Steel Ltd.By-Law No.80 1.The number of the Directors of the Company be, and it is hereby increased from four (4) to five (5). 786 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N9 7 2° Qu'un quorun du bureau de direction soit et il est, par les présentes, fixé à trois (3).3° Que les règlements de la compagnie soient et Us sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.\" Je le soussigné, Secrétaire de \"Standard Structural Steel Ltd.\", certifie par les présentes, que le précédent est un extrait véritable des minutes d'une assemblée du bureau de direction de \"Standard Structural Steel Ltd.\", tenue au bureau de la compagnie à Montréal, le 27e jour d'octobre 1958, et de plus ratifié et confirmé à une assemblée des actionnaires de ladite compagnie tenue à la même date, et à laquelle tous les actionnaires étaient présents, Montréal, 27 octobre 1958.(Sceau) Le Secrétaire, 49891 Mrs.T.B.PICKARD.(P.G.5590-53) Saguenay Industries Limited (Les Industries Saguenay, Limitée) Règlement N° 24 (Changement du nombre des directeurs) \"Résolu: Que le nombre des directeurs de la Compagnie' \"Saguenay Industries Limited\" (Les Industries Saguenay, Limitée), soit et il est par les présentes changé de trois (3) qu'il était auparavant à celui de cinq (5) et le règlement N° VII (a) de la Compagnie est modifié en conséquence.Que M.Jean-Baptiste Hudon, Secrétaire-trésorier de la compagnie, soit et il est par les présentes, autorisé à certifier une copie du présent règlement, et à en requérir la pubhcation dans la Gazette officielle de Québec, conformément aux exigences de la Loi.\" Port-Alfred, le 6 février 1959.Certifié vraie copie.Le Secrétaire-trésorier, 49897-0 (Signé) JEAN-BTE HUDON.Chartes \u2014 Abandon de Don-MAn Realty Limited Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Don-Mar Realty Limited\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 5e jour de février 1959.(Sceau) Le Secrétaire-adjoint, 49866-o E.G.EVANS.J.A.Rainville Limitée Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"J.A.Rainville Limitée\", constituée en corporation en vertu de la loi des compagnies de la province de Québec et ayant son siège social dans la ville de Mistassini, comté de Roberval, s'adressera au Procureur Général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Mistassini, le 5 février 1959.(Sceau) Le Secrétaire, DAME A.LECLERC RAINVILLE.49873-o 2.A quorum of the Board of the Directors be, and the same is hereby fixed at three (3).3.The By-laws of the company be and they are hereby amended to accord with the foregoing.\" I, the undersigned, Secretary, of \"Standard Structural Steel Ltd.\", hereby certify the foregoing to be a true extract of the minutes of a meeting of the Board of Directors of \"Standard Structural Steel Ltd.\", held at the office of the Company in Montreal, on the 27th day of October, 1958, and further ratified and confirmed at a meeting of Shareholders of the said Company held on the same date, at which all the Shareholders were present.Montreal, October 27th, 1958.(Seal) Mrs.T.B.PICKARD, 49891-o Secretary.(A.G.5590-53) Saguenay Industries Limited (Les Industries Saguenay, Limitée) By-law No.24 (Change in the number of Directors) \"Resolved that the number of the directors of the Company \"Saguenay \u2022 Industries Limited\" (Les Industries Saguenay, Limitée), be and it is hereby changed from three (3) that it was heretofore to that of five (5) and By-law No.VII (a) of the company is therefore amended.That Mr.Jean-Baptiste Hudon, Secretary-Treasurer of the Company, be and he is hereby authorized to certify a copy of the present Bylaw, and to require the publication of same in the Quebec Official Gazette, in conformity with the requirements of the Law.\" Port-Alfred, February 6, 1959.Certified true copy.(Signed) JEAN-BTE HUDON, ' 49897 Secretary-Treasurer.Charters\u2014Surrender of Don-Mar Realty Limited Notice is hereby given that \"Don-Mar Realty Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, Quebec, this 5th day of February, 1959.(Seal).E.G.EVANS, 49866-o Assistant-Secretary.J.A.Rainville Limitée Notice is hereby given that the company \"J.A.Rainville Limitée\", incorporated under the Companies' Act, of the Province of Quebec and having its head office in the town of Mistassini, county of Roberval, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for permission to surrender its charter.Mistassini, February 5, 1959.(Seal) DAME A.LECLERC RAINVILLE, Secretary.49873 - QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, VoLBl, No.7 787 Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Ileamoor Investments Ltd.\", conformément à la Loi des Compagnies de Québec s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, en la province de Québec, ce 3e jour de février 1959.Le Secrétaire, 49877 W.G.JOULE.Demande à la Législature Notice is hereby given that \"Heamoor Investments Ltd.\", in accordance with the Quebec Companies' Act, will apply to the Attorney Gene-real of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, in the Province of Quebec, this 3rd day of February, 1959.W.G.JOULE, 49877-o Secretary.Application to Legislature Avis public est, par les présentes, donné, que les Commissaires des Écoles Catholiques Romaines de la cité de Granby, dans le comté de Shef-ford, s'adresseront à la Législature de la Province de Québec, présentement en session, aux fins d'obtenir l'adoption d'une loi leur accordant les Souvoirs d'imposer et prélever une taxe de vente e deux (2%) pour cent, dans les limites de son territoire et de celui de la Commission Scolaire Notre-Dame de Granby, par modification et amendement de la loi 14-15 Georges VI ch.114 S.R.Q.1950-51, actuellement en vigueur et autorisant l'imposition et le prélèvement d'une taxe de vente de un (1%) pour cent, dans les limites de la cité de Granby.Granby, le 20 janvier 1959.L'avocat et l'agent des pétitionnaires, 49721-4-4-0 GLLLES BÉLANGER.Public notice te her eby given that the Roman Catholic, School Commissioners of the city of Granby, in the county of Shefford, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, now in session, to have a law passed authorizing them to impose and levy a \"sale tax\" of two (2%) per cent, m the limits of its territory and of the territory of La Commission Scolaire Notre-Dame de Granby, through amendment of the law 14-15 Georges VI ch.-114, S.R.Q.1950-51, now in force, and authorizing to impose and levy a \"sale tax\" of ones (1%) per cent in the limits of the city of Granby.Granby, January 20th 1959.GILLES BÉLANGER, 49721-4-4-0 Attorney and Agent for Petitioners*.Département de l'Instruction Publique N° 122438.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire de St-Norbert, dans le comté d'Artha-liaska, les territoires suivants, savoir: 1.Le territoire actuel de la municipalité scolaire de Chester-Nord, même comté, comprenant les lots primitifs 15 à 28 inclusivement du rang I et 21 à 28 inclusivement des rangs II, III, IV et V, tous du canton Chester; 2.Les lots primitifs 14 5 inclusivement du rang XIII du canton Arthabaska, lesquels seront détachés de la municipalité scolaire de Ste-Sopine, dans le comté de Mégantic; 3.Les lots primitifs 1 à 5-A inclusivement du rang XII du canton Stanfold, lesquels seront détachés de la municipalité scolaire de Stanfold, dans le comté d'Arthabaska.Québec, le 2 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49816-0-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1090-58.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Carignan, dans le comté de Laviolette, les blocs L et M et les lots 18 à 22 inclusivement du rang II du canton Malhiot, pour les annexer à la municipalité scolaire de la ville de La Tuque, même comté.Québec, le 2 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49817-6-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 551-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 4 février 1959, de changer le nom de la municipalité scolaire de Department of Education No.1224-58.Application is made to annex to the school municipality of St-Norbert, in the county of Arthabaska, the following territories, to wit: 1.The present territory of the school municipality of Chester-North, same county, comprising primitive lots 15 to 28 inclusively of range I and 21 to 28 inclusively of ranges II, III, IV and V, all of the Chester township; 2.Primitive lots 1 to 5 inclusively of range XIII of the Arthabaska township, which shall be detached from the school municipality of Ste-Sophie, in the county of Megantic; 3.Primitive lots 1 to 5-A inclusively of range XII of the Stanfold township which shall be detached from the school municipality of Stanfold, in the county of Arthabaska.Quebec, February 2, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 49816-6-2 Superintendent of Education.No.1090-58 Application is made to detach from the school municipality of Carignan, in the county of Laviolette, blocks L and M and lots 18 to 22 inclusively of range II of the Mailhiot Township, to annex them to the school municipality of the Town of La Tuque, same county.Quebec, February^, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 49817-6-2 Superintendent of Education.No.551-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in council, by order in council dated February 4, 1959, has been pleased to change the name of 788 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québeû, U février 1969, Tome 91, N° 7 St-Benjamin-du-Lac-à-Busque, dans le comté de Dorchester, en celui de St-Benjamin, même comté.Ce changement prendra effet le 22 février 1959.Québec, le 10 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49887-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1366-54.H a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date du 4 février 1959, de détacher de la municipalité scolaire du village de Nomininguc, dans le comté de Labclle, les lots F-l et F-2 rang nord-ouest, ainsi que les lots 59 à 62 inclusivement du rang I, tous du canton Marchand, pour les annexer à la municipalité scolaire de Ste-Véronique-de-Turgeon, même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1959.Québec, le 10 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49887-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1127-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date du 4 février 1959, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de la ville de Saguenay, dans le comté de Chicoutimi, à celle de la paroisse de Chicouti-nii, même comté.Ce territoire comprend les lots 13-a, 13-6, 14-a, 14-6,15,16-a, 16-6 du rang IV nord-est du chemin Sydenham du cadastre officiel de la paroisse de Chicoutimi.De changement prendra effet au 1er juillet 1959.Québec, le 11 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49887-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1218-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date du 4 février 1959, de changer le .nom de la municipalité scolaire de Chatham N° I, dans le comté d'Argenteuil, en celui de St-Philippe, même comté.Ce changement prendra effet le 22 février 1959.Québec, le 11 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49887-0 O.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Vincent de Paul (municipalité de ville de Duvernay), division d'enregistrement de Laval.Avis est par la présente donné que le lot 68-7 (rue) est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 2 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49853-0 A VILA BÊDARD.the school municipality of St-Benjamin-du-Lac-à-Busqué, in the county of Dorchester, into that of St-Beniamin, same county.This order in council will take effect on February 22, 1959.Quebec, February 10, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 49887 Superintendent of Education.No.1366-54.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by order in council, dated February 4, 1959, has been pleased to detach from the school municipality of the village of Nominingue, in the county of Labclle, lots F-l and F-2 northwest range, as well as lots 59 to 62 inclusively of range 1, all of the township of Marchand, to annex them to the school municipality of Ste-Véronique-de-Turgeon, same county.This order in council will take effect on July 1st 1959.Quebec, February 10, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 49887 Superintendent of Education.No.1127-58.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by order in council dated February 4, 1959, to annex the present territory of the School Municipality of the town of Saguenay, in the county of Chicoutimi, to that of the parish of Chicoutimi, same county.This territory comprises lots 13-a, 13-6, 14-a, 14-6, 15, 16-a, 16-6 of range IV north east of the Sydenham Road of the official cadaster of the parish of Chicoutimi.This change shall take effect on July 1st, 1959.Quebec, February 11, 1959.O.J.DÉSAULND2RS, 49887 Superintendent of Education.No.1218-58.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by order in council dated February 4, 1959, to change the name of the School municipality of Chatham No.I, in the county of Argenteuil, to that of St, Philippe, same county.This change shall take effect on February 22, 1959.Quebec, February 11, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 49887 Superintendent of Education.Department of Lands and Forest NOTICE Official cadastre of the parish of St-Vincent de Paul (municipality of town of Duvernay), registration division of Laval.Notice is hereby given that lot 68-7 (Street) has been cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 2,1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÊDARD, 49853-0 Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL 0AZETTE, Quebec, February M, 1969, Vol.91, No.7 789 Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio'Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire de la Boulangerie et de la PAtis-s série des Trois-Rivières'et district, établi en exécution du décret numéro 421 du 29 avril 1954, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 86 du 4 février 1959, section \"C\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés : 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 26 février 1959 au 26 février 1960; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels, régis par le décret numéro 421 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.6) Les artisans régis par le décret numéro 421 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente h Y de 1 % du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $45.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 421 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% de leur rémunération.2.Mode de -perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au comité paritaire A chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire.le ou avant le dix (10) du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le comité a le pouvoir d'exiger l'asscrmentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rap- Sort trimestriel de ses opérations financières au linistre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 Septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de la Boulangerie et de la Pâtisserie des Trois-Rivières et district, Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that le Comité paritaire de la Boulangerie et de la Pâtisserie des Trois-Rivières et district, formed under decree No.421 of April 29,1954, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.86 of February 4, 1959, part \"C\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act,\" to levy assessments upon the professional employers, the aritsans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereunder described: 1.Assessments The period of levy extends from February _ 26, 1959 to February 26, 1960; the levy shall be applied as follows; a) The professional employers governed by the decree No.421, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of their payroll in respect of the employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the decree No.421, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount eouivalcnt to )>$ of 1% of the lowest wages established fc r journeymen, i.e.$ 15.00 per week.c) The employees governed by the decree No.421, and amendments, shall pay to the Parity ('( mmittee an amount equivalent to ^ of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee furnishes the professional employers with report forms on^ which all particulars required by the Committee v shall be given.The professional employer shall complete and sign his report and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assissments of his employees by means of a deduction from their wages.The professional employer shall forward his -monthly report to the Parity Committee on or before the 10th of the month following the date of expiration of the ])eriod for which it is exigible; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The committee may require sworn reports when deemed advisable.The levy laid by the present by-law is payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, five (5) days notice will be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of his financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Comité paritaire de la Boulangerie et de la Pâtisserie des Trois-Rivières 790 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7_ Comité paritaire de la Boulangerie et de la Pâtisserie des Trois-Rivières et District Comité paritaire de la Boulangerie et de la Pâtisserie des Trois-Rivières et district État des recettes et des déboursés probables pour Estimate of the receipts and disbursements for la période dse terminant le 26 février 1960.the period ending February 26, 1960.période Recettes: Cotisations {M de 1%): Employeurs professionnels.$1,510.00 Artisans.40.00 Salariés.1,510.00 Receipts: Assessments (J4 °f 1%): Professional employers.$1.510.00 Artisans.40.00 Employees.1,610.00 Honoraires d'examens.40.00 Examination fees 40.00 $3,100.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 14 février 1959.49852-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis, par les présentes que le Comité paritaire du Commerce de l'Alimentation en Détail à Québec, établis en exécution du décret numéro 1658, du 17 mai 1944, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 86 du 4 février 1959, section \"B\", le tout conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après: $3,100.00 Déboursés: Salaires: Inspecteur.$ 300.00 Administration.500.00 Loyer du bureau.200.00 Frais légaux.§.200.00 Papeterie, impression, timbres, téléphone et télégrammes.150.00 Ameublement et accessoires de bureau 200.00 Vérification des livres.40.00 Assurances et frais de cautionnement 5.00 Frais de déplacement du président et des membres.500.00 Jetons de présence aux membres du Comité.240.00 Bureau des examinateurs.150.00 Dépréciation.100.00 Dépenses diverses et imprévus.515.00 $3,100.00 Disbursements: Salaries: Inspector.$ 300.00 Administration.500.00 Office rent.200.00 Legal fees.200.00 Stationery, printing, postage, telephone and telegrams.150.00 Furniture and office equipment.200.00 Audition.40.00 Insu ranee, and fidelity bond.5.00 Travelling expenses of president and members.500.00 Meeting expenses of committee mem- v hers.;.240.00 Board of Examiners.150.0Q Depreciation.100.00 Various and unforeseen expenses .515.00 $3,100.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 14.1959.49852-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Retail Food Trade Parity Committee of Quebec, formed under decree number 1658, of May 17, 1944, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 86 of February 4, 1959, part \"B\", pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned : 1.Cotisation 1.Assessments La période de cotisation s'étend du 1er mars 1959 au 28 février 1960; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) lies employeurs professionnels régis par le décret numéro 1658 et ses amendements, doivent payer au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% des salaires, bonis ou allocations payés à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les salariés régis par le décret numéro 1658 et ses amendements doivent payer au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur rémunération.The period of levy extends from March 1, 1959, to February 28, 1960, and applies as follows: a) The professional employers governed by decree number 1658, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yz of 1% of the wages, bonuses or allowances paid to their employees governed by the said decree.6) The 'employees governed by the decree number 1658, and amendments, shall pay \"to the Parity Committee a sum equivalent to % of 1% of their wages, bonuses or allowances.Dour'la période comprise entre le 26 février 1959 et district for the period between February 26, et le 26 février 1960.1959 and February 26, 1960. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Wh, 1969, Vol.91, No.7 791 c) Les artisans régis par le décret numéro 1658 et amendements doivent payer au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% du salaire établis dans ledit décret pour le salarié le moins rémunéré, suivant leur emploi.2.Mode de perception A chaque mois, l'employeur professionnel doit fournir au Comité paritaire un rapport détaillé indiquant sur les formules mises à sa disposition par ledit Comité paritaire, les noms, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.Ce rapport dûment signé par l'employeur professionnel doit être accompagné des cotisations payables au Comité paritaire par ledit employeur professionnel et par ses salariés; toutes ces sommes doivent être payées en deniers ayant cours légal dans la province de Québec.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine à même le salaire de chacun de ses salariés les sommes ducs au Comité paritaire à titre de prélèvement.Les cotisations sont payables mensuellement entre le 1er et le 10 de chaque mois.Le Comité paritaire a le droit d'exiger l'asscr-mentation des rapports mensuels des employeurs professionnels chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier Selon les termes de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité paritaire du Commerce de l'Alimentation au détail à Québec, pour la période comprise entre le 1er mars 1959 et le 28 février 1960.Comité paritaire du commerce de l'Alimentation \\v détail à Québec c) The artisans governed by the decree, number 1658, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to % of 1% of the lowest wage rate mentioned in the said decree for employees of similar occupations.2.Mode of collection Every month, the professional employer shall forward to the Parity Committee a complete report, on forms supplied by the said Committee, giving the name in full and address of all employees in his employ, their competency or classification, the number of regular or overtime hours worked each week, the nature of such work and the wages paid.The report shall be signed by the Professional employer and sent to the Parity Committee, together with the assessments owed by the said professional employer and his employees.All such sums shall be paid with money that is current in this Province.The professional employer^ shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee.Assessments shall be paid every month, between the 1st and the 10th day of each month.The Parity Committee has the right to exact sworn monthly reports from the professional employers when deemed advisable.3.Financial report According to the provisions of the Collective Agreement Act.the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial activities on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Retail Food Trade Parity Committee of Quebec for the period between March 1,1959 and February 28,1960.The Retail Foof Trade Parity Committee of Quebec État des recettes et des déboursés probables Estimate of reoeips and disbursements for pour la période comprise entre le 1er mars the period between March 1, 1959 and Fe-1959 et le 28 février 1960.bruary 28, 1960.Recettes: Cotisations (14 de 1%) : Employeurs professionnels.$21,975.00 Salariés.21,975.00 Pénalités.50 00 Receipts: Assessments of 1%) : Professional employers.$21,975.00 Employees.21,975.00 Penalties.50.00 $44,000.00 $44,000.00 Déboursés: Administration.$11,232.00 Inspecteurs-salaires.*é.15,600.00 Inspecteurs-dépenses.1,275.00 Bureau des Examinateurs.2,000.00 Loyer et éclairage.1,800.00 Frais judiciaires et professionnels.3,900.00 Impression.925.00 Papeterie.175.00 Ameublement.150.00 Comité \u2014 jetons de présence.- 1,120.00 Frais de déplacement du Comité- 2,380.00 Divers.850.00 Annonces.1.500.00 Poste-téléphone.800.00 Charges de banque.5 00 Disbursements: Administration.$11,232.00 Inspectors' salaries.15,600.00 Inspectors' travelling expenses.1,275.00 Board of examiners.2,000.00 Rent and lighting.1,800.00 Judicial and professional fees.3,900.00 Printing.925.00 Stationery.175.00 Furniture.150.00 Meeting expenses.1,120.00 Members' transportation expenses.2,380.00 Miscellaneous.850.00 Publicity.1,500.00 Postage, telephone.800.00 Bank charges.5.00 792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7 Assurances.210.00 Surplus.78.00 $44,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 14 février 1959.49852-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de là convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux épiciers et bouchers de Sherbrooke, rendue obligatoire par Je décret numéro 20 du 5 janvier 1955,, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1° La désignation des parties contractantes sera modifiée pour se lire comme suit: \"D'une paut: L'Association des Détaillants en Alimentation du Québec, section de Sherbrooke ; Et, d'autre part: United Construction Workers, Division of District 50, U.M.W.A.au nom du Local 658, U.C.W.\" 2° Le paragraphe \"1\" suivant sera ajouté à l'article I: \"1) Artisan: Le mot \"artisan\" désigne toute personne qui exploite ou opère elle-même, seule ou en société, avec une ou plusieurs autres personnes, pour son ou leur propre bénéfice, un des commerces définis à l'article I.\" 3° Le paragraphe \"b\" de l'article II sera remplacé par le suivant: \"b) Territoriale: Le décret s'applique à la cité de Sherbrooke et un rayon de S milles de ses limites.\" 4° Les paragraphes \"a\" et \"c\" de l'article III-seront remplacés par les suivants: \"III.Heures de travail: u) Ia?s heures de travail de la semaine régidière sont réparties comme suit : Les lundi, mardi et jeudi: S.00 a.m.à 0.00 p.m.Le mercredi: S.00 a.m.à 12.30 p.m.(midi et trente minutes) Le vendredi: S.00 a.m.à 9.30 p.m.Le samedi: 8.00 a.m.à 4.30 p.m.\" \"c) Pour les fins d'application du présent décret, les heures de travail de l'artisan sont celles du \"commis\".Clause du Marché Public: Lorsque le marché public est en opération un jour autre (pie le vendredi, les heures de travail sont alors de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.le vendredi et de 8.00 a.m.à 9.30 p.m.le jour du Marché Public.Clause générale: Nul ne peut travailler à la vente ou à la livraison d'effets couverts par le présent décret en dehors des heures établies à l'artiefe III.\" 5° L'article IX sera remplacé par le suivant: \"IX.Durée du décret: Le décret entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette Officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 15 janvier 1960.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que Insurance.\u2022 210.00 Surplus.:.78.00 $44,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 14, 1959.49852-o \" NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the grocers and butchers of Sherbrooke, rendered obligatory by the decree No.20 of January 5, 1955, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: 1.The designation of the contracting parties* shall be amended to read as follows: \"On.tjie one part: The Province of Quebec Food Retailers' Association, section of Sherbrooke; And, on the other part: United Construction.Workers, Division of District 50, U.M.W.A.,'on behalf of Local 658, U.C.W.\" 2.The following paragraph \"1\" will be added to article I: \"1) Artisan: The word \"artisan\" mens any person who keeps or operates himself, alone or in partnership, with one or many other persons, for his or their own benefit, one of the commercial establishments described in Article I.\" 3.Paragraph \"6\" of article II will be replaced by the following: b) Territorial: The decree applies to the city of Sherbrooke and a radius of 8 miles from its limits.\" 4° Paragraphs \"a\" and \"c\" of article III will be replaced by the following.: \"III.Working hours: a) The working hours of the standard week shall be distributed as follows: On Monday, Tuesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.On Wednesday: 8.00 a.m.to 12.30 p.m.On Friday: 8.00 a.m.to 9.30 p.m.On Saturday: 8.00 a.m.to 4.30 p.m.\" \"e) For the purposes of the present decree, the working hours for the artisan are the same as for the \"clerk\".Provision for the Public Market: Whenever the public market is in operation on any one day outside of Friday, the working hours will then be from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.on Friday and from 8.00 a.m.to 9.30 p.m.on the day the public market is opened.General Provision: No one is allowed to sell or deliver any merchandise governed by the present decree outside the hours indicated in Article III.\" 5.Article IX will be replaced by the following: \"IX.Duration of the decree: The decree comes into force on the day of its publication in the Quebec Official Gazette and remains effective until Januray 15, 1960.It then renews itself automatically from year to year unless one of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Wh, 1969, Vol.91, No.7 793 l'une ou l'autre des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit de son intention d'y mettre fin, dans un délai de pas plus de soixante (60) jours ni de moins de trente (30) jours avant l'expiration du terme original ou de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions,-avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honoralbe ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.lie Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 14 février 1959.49852-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux établissements commerciaux dans la ville de Coaticook et un rayon de deux (2) milles de ses limites, rendue obligatoire par le décret numéro 102 du 10 février 1954, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: Ie Le paragraphe \"c\" de l'article III sera remplacé par le suivant: \"c) Lorsqu'il y a un jour férié pendant la semaine, les heures régulières de travail sont de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.le mercredi.De plus, lorsque le vendredi est un jour férié, les heures régulières de travail sont de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.le jeudi.\" 2° Les mots \"le 24 mai\" apparaissant à l'article V seront remplacés par les mots \"la fête de la Reine\".La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires des dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.x Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 14 février 1959.49852-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), qu'il se propose de recommander l'approbation des modifications suivantes contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary, within the period extending from the 60th to the 30th day before the expiration of the original term or of any subsequent year.\u2022 Such a notice shall also be given to the Minister of Labour.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only lie rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Québec Official' Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 14, 1959.49852-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, the Minister of Labour, hereby gives, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to commercial establishments in the town of Coaticook and a radius of two (2) miles from its limits, rendered obligatory by the decree number 102 cf February 10, 1954, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: 1.Paragraph \"c\" of article HI will be replaced by the following: \"c) When a holiday falls in a week, Wednesday is worked all day from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Moreover, when a holiday falls on a Friday, the hours of work on Thursday shall be from 8.00 a.m.to 10.00 p.m.\" 2.The words \"May 24\" appearing in article V will be replaced by the words \"Queen's Birthday\".The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.«.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, February 14, 1959.49852-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of section 8 of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that he intends to recommend the approval of the following amendments to the GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1969, Tome 91, N° 7 au décret numéro 184 du 8 février 1960, et amen-dements, relatif aux employés de garages dans l'Ile de Montréal: 1° Les mots suivants seront biffés du paragraphe j) de l'article I: \"Ne sont pas considérés comme débits «l'essence, les établissements couverts d'une surface d'entreposage intérieur de véhicules-moteurs de plus de 3,000 pieds carrés.\" 2° Ixs mots suivants seront biffés du paragraphe k) de l'article I: \"Sont également considérés comme garages, les débits d'essence des établissements couverts d'une surface d'entreposage intérieur de véhiculés-moteurs de plus de 3,000 pieds carrés.\" 3° Le sous-paragraphe suivant sera biffé du paragraphe b) de l'article IV: \"6.Nonobstant toute disposition à ce contraire, il est interdit aux hommes de service employés dans les débits d'essence, de faire aucune «les tâches comprises dans la définition du terme \"Hommes de Service\" contenue dans le présent décret, entre minuit et une minute le dimanche, et minuit et une minute le lundi.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositrons qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'Arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la (azelte officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 14 février 1859.4CS52-o decree number 184 of February 8, 1950, and amendments, relating to the garage employees of the Island of Montreal: 1.The following words will be deleted from paragraph j) of article I : \"All roofed establishments where the inside storing surface exceeds 3,000 square feet shall not be considered as gasoline stations.\" 2.The following words will be deleted from pi-rag rap h k) of article I: \"Gasoline stations where the inside storing surface exceeds 3,000 square feet shall also l>e considered as garages.\" 3.The following sub-paragraph will be deleted from paragraph b) of article IV: \"5.Notwithstanding any other provision to the contrary, no service man employed in gasoline stations shall do any of the operations mentioned in the definition of the term \"service man\" in the present dedree between the hours of 12.01 a.m.Sunday and 12.01 a.m.Monday.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the dute of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Lal>our.Department of Labour, Quebec, February 14, 1959.49852-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative â l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Hull, rendue obligatoire par le décret numéro 810 du 14 août 1957 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et â la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit .décret: 1° Le paragraphe \"c\" de l'article II, sera remplacé par le suivant: \"c) Nonobstant les dispositions du paragraphe \"c\" de l'article I du décret, un spécialiste en posage de châssis, fenêtres, paravants, divisions, et portes en métal, n'est pas soumis à l'exigence de la carte de compétence des charpentiers-menuisiers, mais doit en recevoir le même salai- _ 2° Les taux 3e salaires minima pour les métiers ci-après mentionnés, apparaissant à l'article V, paragraphe \"a\", seront remplacés par les suivants: Taux horaire* Zones I U \"Briqueteur.$ 2.00 % 1.75 Charpentier-menuisier.2.15 1.60 Journalier.1.20 1.10 Maçon.2.00 L75 Manœuvre.1.30 1.15 NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the* Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry, and trades in the region of Hull, rendered obligatory by the decree number 810 of August 14, 1957 ami amendments, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree: 1.Paragraph \"c\" of article II, will l>c replaced by the following: \"c) Notwithstanding the provisions of subsection \"c\" of section I of the present decree, an expert metal frame, window, screen partition or door layer is not required to hold the carpenter-joiner's card but he shall be paid the same wage rate.\" .2.The minimum wage rates for the trades hereafter mentioned, appearing in article V, paragraph \"a\", will be replaced by the following: Hourly rates Zones I II \"Bricklayer.$ 2.00 s 1.75 Carpenter-Joiner.2.15 1.60 Common worker.1.20 1.10 Mason.2.00 1.75 Labourer.1.30 1.15 ,-\u2014.v.- \" \u2022 QUEBEC.OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol.91, No.7 795 Peintre avec machine pneuma- que.$ 1.90 $ 1.65 Painter, spraying.$ 1.90 $ 1.65 Peintre, décorateur.1.75 1.50 Painter, decorator.1.75 1.50 Gardien, (par semaine).50.00 40.00\" Watchman (per week).50.00 40.00\" 3° Les mots \"deux pour cent (2%)\" apparaissant au paragraphe \"e\" de l'article VIII, seront remplacés par les mots \"quatre pour cent (4%)\".4 Les mots \"le 1er novembre\" apparaissant à la fin de l'article XV, seront remplacés par les mots \"le 1er février\".La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 14 février 1959.49852-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de garage dans le district électoral de Drummond, rendue obligatoire par le décret numéro 102 du 31 janvier 1957 et amendement, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1° Le paragraphe \"aa\" suivant sera ajouté après le paragraphe \"a\" de l'article I: \"aa) Le mot \"artisan\" désigne toute personne faisant, seule ou en société, ,un travail régi par le décret ou tout employeur ou employeur professionnel lorsqu'il fait pareil travail.\" 2° Le paragraphe \"d\" de l'article I sera remplacé par le suivant: \"d) Le mot \"garage\" désigne tout endroit où les véhicules-moteurs sont réparés, transformés, démolis ou remisés.Sont considérés comme garages et, par conséquent, assujettis au décret, tous les établissements où se fait exclusivement et autrement la réparation ou le ieconditionnement des moteurs, des accessoires ou pièces nécessaires à la conduite ou au fonctionnement d'un véhicule-moteur, que ces accessoires ou pièces soient séparés du véhicule-moteur ou non.\" 3° Le paragraphe \"e covered with le terrazzo, mesure, divise cette surface et y terrazzo, measures and divides such surfaces trace les lignes, prépare les échantillons et and draws the lines thereon, prepares the samples mélange le matériau, étend cette composition and mixes the material, spreads this composition et surveille le roulage et le polissage du terrazzo.and supervises the rolling and polishing of terrazzo.ce) Le mot \"tôlier\" désigne tout salarié qui ce) The words \"tinsmith\" or \"sheet metal taille ou pose la tôle, soit à Ta boutique ou sur le worker\" means an employee whose work consists chantier.in cutting and laying sheet metal in the shop or on the job.dd) \\a} terme \"travailleur en fer et bronze dd) The words \"ornamental iron and bronze d'ornementation\" désigne tout salarié qui fait worker\" means a worker sho traces, cuts, prépaie tracé, la coupe, la préparation et l'assemblage res and assembles by means of machines, tools au moyen de machines, d'outils ou de soudure, or welding, any iron, bronze and steel pieces for GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 14 février 1969, Tome 91, N° 7 de toutes pièces de fer, bronze et acier pour fabrication d'escaliers, intérieurs ou extérieurs, de garde-corps, de clôtures, de barrières, de châssis, de marquises, de trappes de cave ou d'inspection, de grillagé de tous genres, de chute à charbon, de portes de voûtes, de portes coupe-feu, de divisions et d'appareils de sauvetage ou tout travail connexe et qui en fait l'installation ou le montage.ee) Le terme \"travailleur de fer structural\" désigne tout salarié qui pose les structures métalliques dans les travaux de construction d'édifices, ponts, viaducs, tunnels, etc.et qui fait, au besoin, tout autre travail connexe.ff) Le terme \"vérificateur de matériaux\" désigne tout salarié qui reçoit les matériaux ou l'outillage nécessaire à un chantier de construction, les classe, les livre et fait tout autre travail de même nature ou connexe.Particularités dans l'exercice de certains métiers: Le travail sur les murs qui fait suite au travail de parquet se limite pour le finisseur de béton à la hauteur de la plinthe, sauf pour les étages plus bas que le rez-de-chaussée.II.Juridiction territoriale: La présente convention s'applique aux districts électoraux d'Abi-tibi-Est, d'Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda, Cette juridiction est divisée en deux (2) zones comme suit: Zone I: Le district électoral de Rouyn-Noranda, les cités ou ville de Malartic, Val d'Or, Bourlamaque, Chibougumau et Chapais ainsi que le territoire compris dans un rayon de dix (10) milles de leurs limites.Zone II: Le reste de la juridiction territoriale.III.Juridiction industrielle: a) La présente convention s'applique à tous les travaux de construction de bâtiment et de génie civil, y compris les travaux d'installation de réfection de répara- .tion, d'entretien, de démolition, de déplacement d'immeubles, exécutés par les ouvriers qu'elle vise.Elle s'applique entre autres à tous les travaux de bâtisses, d'immeubles, échafaudages, pavages de rues et de routes, chemins, ponts, barrages, rues, quais, trottoirs, nivellement et terrassement, murs de soutènements, égouts, viaducs, aéroports, terrains d'atterrissage, tunnels puits, canaux, écluses, aqueducs, clôtures, tours, système de plomberie, système de chauffage, installation électrique, et à tout autre travail de même nature ou connexe.6) La présente convention s'applique également à tout travail assujetti à la Loi des mécaniciens en tuyauterie (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 173) et à toute installation en tuyauterie, fixe ou mobile, pour quelque usage que ce soit, nécessitant l'habileté et la compétence d'un mécanicien en tuyauterie, exécuté à l'intérieur ou à l'extérieur de toute bâtisse, y compris les travaux d'installation, de réparation et de rénovation.c) Elle s'applique également à tous les employeurs et salariés exécutant des travaux de tous genres avec du liège ou de l'amiante, pour fins de congélation, de chauffage ou d'isolement, se rattachant au métier de mécanicien en tuyauterie.Les salariés qui participent à ces opérations doivent être payés suivant les salaires établis pour leur catégorie dans la présente convention et ce, pour les fins d'installation et de service.d) Le lavage et le nettoyage préparatoires aux travaux de peinture et de décoration faits à l'extérieur ou à l'intérieur des églises, chapelles, ainsi qu'à tout autre édifice public, sont assujettis à la présente convention et les salariés qui y sont employés sont considérés comme des journaliers.the fabrication of inside or outside staircases, handrails, fences, gates, sashes, marquises, cellar or inspection trap-doors, all kinds of gratings, coal slide boards, vauld doors, fire doors, partitions and life-saving apparatus or who does any work of the same nature or related thereto, and installs or erects same.ee) The words \"structural steel worker\" designate an employee who erects structural steel in the construction of buildings, bridges, viaducts, tunnel and so forth, and performs any other work related thereto, as required.ff) The words \"material checker\" means any employee who receives the material or the tools required on a construction job, classifies and delivers same, and does any other work of the same nature or connected therewith.Special provisions applying to certain trades: Except for floors under ground level, work on walls by concrete finishers, to be done after floor-work, shall not come any higher than the top of the plinth.II.Territorial jurisdiction: The present agreement shall apply to the electoral districts of Abitibi-Easf, Abitibi-West and Rcuyn Noranda.This jurisdiction is divided into two zones, as follows: Zone /.-The electoral district of Rouyn-Noranda, the cities or town Malartic, Val d'Or, Bourlamaque, Chibougamau and Chapais and the territory comprised in a radius of ten (10) miles from their limits.Zone II: The remainder of the territorial jurisdiction.III.Industrial jurisdiction: a) The present agreement applies to all works pertaining to construction, building and engineering, including the installation, rebuilding, repairing, maintenance, demolishing, displacement of buildings performed by the workers it governs.It extends, but is not limited to all work in connection with buildings, properties, scaffoldings, paving of streets and highways, roads, bridges, dams, streets, wharves, sidewalks, levelling and earthwork, retaining walls, sewers, viaducts airports, landing fields, tunnels, wells, canals, lock-gates, aqueducts, fencel, towers, plumbing and heating systems, electrical installations, and to any other work of the same kind or related thereto.b) The present agreement also applies to any work governed by the Pipe-Mechanics Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 173) and to any installation of piping, immovable or portable, intended for any use whatsoever, requiring the skill and competency of a pipe mechanic, performed inside or outside any building, including installation, repair ami renovation.c) It also applies to all employers and employees doing all kinds of work with cork or asbestos, for refrigerating heating or insulating purposes, connected with the pipe-mechanic trade.Workers carrying out such operations shall be paid according to the rates of wages established for their category in the present agreement for both installation and service purposes.- d) Washing and cleaning done prior to painting and decorating operations inside or outside churches, chapels or any other public building, are governed by the present agreement and all male employees doing such work are considered as labourers. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1959, Vol 91, No.7 801 e) La présente convention régit également l'installation des ascenseurs et la construction de générateurs de vapeur, de chaudières et de réservoirs et l'installation de structure ou charpente métallique./) Exemptions: 1° Les employeurs de l'industrie de la pulpe et du papier, de .l'industrie de l'aluminium, et de l'industrie de génération d'énergie électrique sont exempts des dispositions du décret pour ce qui concerne l'entretien de leurs propriétés, mais à condition qu'une convention collective de travail particulière négociée avec une union bona fide soit en vigueur.Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent les travaux visés par l'ordonnance numéro 30 de la Commission du Salaire minimum, notamment et y compris la construction de routes, camps et autres aménagements nécessaires aux opérations forestières, tels que digues, écluses, estacades, dalles, etc., ne sont pas assujettis au présent décret.2° L'exploitation des mines ainsi que l'opération et l'entretien de tous les ateliers connexes, y compris les ateliers de traitement, usines de fonte (smellers) et usines d'affinage de métaux, sont exemptés des dispositions de ce décret.3° Les compagnies de chemins de fer à vapeur ne sont pas assujettis au présent décret lorsqu'il s'agit de travaux ordinairement exécutés par les préposés à l'entretien du réseau qui sont déjà régis par une convention collective avec lesdites compagnies de chemins de fer.4° Les travaux de voirie exécutés pour le compte de l'un ou l'autre des départements du Gouvernement provincial déjà assujettis en fait à la cédule des Justes Salaires en exécution de l'arrêté ministériel numéro 800 du 24 avril 1929 et ses amendements, ne sont pas régis par les dispositions du présent décret.5° Dispositions spéciales: Nonobstant toute autre disposition, les cités et villes et les corporations municipales ou scolaires ne sont pas assujetties aux dispositions du présent décret pour ce qui est des travaux de réparation et d'entretien des immeubles qu'elles possèdent; pour ce qui est également des travaux de construction, de réfection ou d'entretien d'aqueducs, d'égouts, de pavages, de trottoirs et autres travaux du même genre exécutés sous leur contrôle immédiat.L'exemption ne s'applique pas, cependant, aux entrepreneurs ou aux sous-entrepreneurs qui exécutent les mêmes travaux en régis ou à forfait pour le compte desdites cités, villes ou corporations municipales ou scolaires.IV.Durée du travail: a) La journée régulière de travail est de huit (S) heures, la semaine régulière de travail est de quarante-huit (48) heures réparties en six (6) jours de huit (8) heures chacune, excepté pour le cas des gardiens.La semaine régulière de travail est réduite d'autant de fois huit (8) heures que cette semaine contient de jours chômés mentionnés dans la présente convention.b) Tout travail supplémentaire doit être rémunéré comme suit, excepté dans le cas des gardiens: salaire et demi par rapport au salaire régulier pour tout travail exécuté en plus de dix (10) heures, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, ou de cinq (5) heures le samedi avant-midi.Tout travail exécuté après midi le samedi doit également être rémunéré au taux de salaire et demi.c) Il n'y a pas de travail les dimanches et les jours de fêtes suivants: Le premier de l'An, le jour de Noël, l'Epiphanie, l'Ascension, la Tous- e) The present agreement also applies to the installation of elevators and the construction of steam generators, boilers and tanks and to the installation of metal structures or frame-work.\u2022¦ /) Exemptions: 1.The employers of the pulp and paper industry, of the aluminum, mining and power industries are exempt from the provisions of the decree as regards the maintenance of their properties and provided a private collective labour agreement, entered into with a bona fide union, be in force.Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, all operations governed by Ordinance number 39 of the Minimum Wage Commission, specially and including the construction of roads, camps and other installations required in forest operations, such as dikes, dams, booms, piers, flumes or chutes, etc., are not governed by the present decree.2.The operation of mines, including operation and maintenance of all plants in connection therewith, such as process plants, smelters, and metal refining plants are exempt from the provisions of this decree.3.Steam railroad compagnies arc not governed by the present decree in the case of works ordinarily performed by maintenance men of the system who are already covered by a collective agreement with the said railroad companies.4.Read operations carried out on behalf of any Department of the Provincial Government, and already governed by the Fair Wage Schedule under Order in Council number 800 of April 24, 1929 and its amendments, are not governed by the provisions of the present decree.5.Special provision: Notwithstanding any other provision, the cities and towns and municipal or school corporations are not governed by the provisions of the present decree inasmuch as repair or maintenance work on their own building are concerned; inasmuch also as construction, rebuilding or maintenance works on-aqueducts, sewérs, paving, sidewalks and qther works of the same kind j>crformed under their immediate control are concerned.The exemption does not apply, however, to contractors or sub-contractors carrying out the same works on their behalf or by the job for the said cities, towns or municipal or school corporations.IV.Duration of work: a) The standard work day shall consist of eight (8) hours and the standard work week shall consist of forty-eight (48) hours divided into 0 days of eight (8) hours each, except for watchmen.The standard work week is reduced by as many times eight (8) hours as there are, in that week, days kept as holidays under the present agreement.b) Overtime shall be paid as follows, except for watchmen: Time and a half, based on the regular rate of pay, for all time worked in excess of ten (10) hours on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, or in excess of five (5) hours on Saturday morning; all time worked after 12.00 (noon) on Saturday shall also be paid at the rate of time and one half.c) There shall be no work on Sunday and the following holidays: New Year's Day, Christmas Day, Epiphany Day, Ascension Day, AH Saints 802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, H février 1959, Tome 91, N° 7 saint, l'Immaculée Conception, la fête du Travail, la St-.Iean-Baptiste et le Vendredi-Saint.d) Tout travail régi par le décret et exécuté les jours mentionnés au paragraphe \"c\" du présent article doit être rémunéré à raison de salaiie double par rapport au salaire régulier, excepté pour le cas des gardiens.e) Construction de routes: La construction de routes a un caractère saisonnier, à cause de la température, et clic ne peut être faite avec sécurité que du mois de mai au mois de septembre inclusivement.La semaine régulière du travail pour les salariés qui y sont employés est de soixante (00) heures,.sans limitation quotidienne de la journée de travail.Tout travail exécuté en plus de ce nombre de soixante (60) heures pendant une même semaine de calendrier doit être rémunéré à raison de salaire et demi par rapport au salaire régulier.V.Taux minima de salaires: a) Les taux minima de salaires suivants doivent être payés: Zones Métiers : I II Briquetcur.81.75 $1.65 Charpentier-menuisier.1.60 1.50 Chauffeur de chaudières.1.45 1.35 Chauffeur de camion de toutes sortes.130 1.25 Conducteur d'attelage.1.30 1.25 Couvreur.1.40 1.40 Électricien.1.55 1.45 Électricien (homme de ligne).1.50 1.40 Faiseur de planchers.1.55 1.45 Finisseur de ciment (béton).1.50 1.40 Foreur.1.40 1.35 Forgeron (préposé aux machines \"drill-sharpeners\").1.70 1.60 Forgeron sur la construction ordinaire.1.50 1.40 Gardien et chauffeur de chaudières, (bouilloires).1.30 1.30 Grécur (travail au sol ou élevé).1.50 1.40 Journalier.1.25 1.15 Manœuvre.1.30 1.20 Mécanicien.1.60 1.50 Mécanicien (Machines fixes ou portatives).1.50 1.40 Mécanicien d'installation à vapeur 2.10 2.10 Mécanicien en tuyauterie, plombier, poseur d'appareils de chauffage, poseur de brûleurs à l'huile.1.75 1.65 Compagnon junior.1.55 1.45 Ouvriers en construction et entretien de moulin.1.50 .1.40 Peintre.1.50 1.40 Peintre préposé aux machines à asperger.1.50 1.40 Peintre travaillant à plus de 45 pieds à l'extérieur, décorateur et doreur.1.60 1.50 Polisseur de terrazzo à sec.1.50 1.40 Polisseur de terrazzo humide.1.40 1.30 Porteur d'eau.0.85 0.85 Poseur de gicleurs-.1.60 1.50 Poseur de lattes en bois ou métalliques.1.50 1.40 Poseur de linoléum.;.1.50 1.40 Poseur de marbre.1.50 1.45 Poseur de terrazzo.1.50 1.45 Poseur de recouvrement calorifuge en amiante ou en autre matériau similaire pour les mêmes fins.1.30 1.20 Poseur de tuile de céramique.1.50 1.45 Poseur et travailleur d'acier d'armature (chantier).1.30 1.25 Poseur de métal ornemental.1.50 1.40 Day, Immaculate Conception Day, Labour Day, St.Jean Baptiste Day and Good-Friday.d) All operations governed by the present decree and performed on days mentioned in paragrph \"c\" of the present article shall be paid double time, except in the case of watchmen.\\fH e) Road construction: The construction of roads in seasonal in .nature and, because of weather conditions, can be carried out safety only between the months of May and September inclusively.The standard work week of employees concerned consists of sixty (60) hours, without daily limitation of the duration of work.All time worked in excess of sixty (60) hours in any one week shall be paid at the rate of time and one half based on regular rates of pay.V.Minimum wage rates: a) The following shall be the minimum wage rates: Zones Trades: I II Bricklayer.$1.75 $1.65 Carpenter-joiner.1.60 1.50 Boiler fireman.1.45 1.35 Truck driver.1.30 1.25 Horse driver.130 1.25 Roofer.1.40 1.40 Electrician.1.55 1.45 Electrician (lineman).1.50 1.40 Floor maker.1.55 1.45 Concrete finisher (cement).1.50 1.40 Driller.140 1.35 Blacksmith (drill-sharpener operator).1.70 1.60 Blacksmith on ordinary construction.150 1.40 Watchman and boiler fireman.1.30 1.30 Rigger (ground work or high line).1.50 1.40 Common worker.1.25 1.15 Labourer.130 1.20 Mechanic.160 1.50 Engincman (stationary or portable engines).1.50 1.40 Steam mechanic.2.10 2.10 Pipe mechanic, plumber, steamfit- tcr, oil burner mechanic.1.75 1.65 Junior joui neyman.1.55 1.45 Mill construction and maintenance worker.1.50 1.40 Painter.150 1.40 Spray painter.1.50 1.40 Painter, work done outdoors at a height exceeding 45 feet, decorator, gilder.1.60 1.50 Terrazzo polisher, dry process.1.50 1.40 Terrazzo polisher, wet process.1.40 1.30 Water carrier.0.85 0.85 Sprinkler fitter.1.60 1.50 Lat her, wood or metal.1.50 1.40 Linoleum layer.1.50 1.40 Marble layer.1.50 1.45 Terrazzo setter.1.50 1.45 Insulation, layer (asbestos or other similar material for the same purses).1.30 1.20 Ceramic tile layer.'.1.50 1.45 Reinforcing steel erector and worker (field).1.30 1.25 Ornamental steel erector.1.50 1.40 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 14th, 1969, Vol 91, No.7 803 Poudrier.$1.50 Préposé au bélier mécanique.1.60 Préposé aux compresseurs, malaxeurs de tous genres.1.40 Préposé aux grues ou pelles à va- peur, à gazoline, à l'électricité ou à l'huile.1.65 Préposé aux monte-charge.1.50 Préposé aux pompes de tous genres 1.30 Soudeur.1.65 Tailleur de granit.1.60 Tireurs de joints.1.50 Tôlier.1.00 $1.50 Blaster.$1.50 $1.50 1.50 Bulldozer operator.1.60 1.50 Compressors, mixers (all ' kinds) 1.35 operator.1.40 1.35 Steam, gasoline, electric, crude oil 1.55 crane or shovel operator.1.65 1.55 1.40 Freight elevator operator.1.50 1.40 1.30 Pumps (all kinds) operator.1.30 1.30 1.60 Welder.1 65 1.60 1.50 Granite cutter.1.60 1.50 1.40 Joint pointer*.1.50 1.40 1.50 Tinsmith.1.60 1.50 Par semaine Chauffeur dc camion de service.850.00 847.50 Gardien sur chantier.50.00 47.50 Pointeur.45.00 42.50 Vérificateur de matériaux.50.00 47.50 6) Salaires minima des apprentis: Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux apprentis des métiers ci-après mentionnés: Métiers en général: 1ère année.40% du salaire du compagnon 2ème année.55% du salaire du compagnon 3ème année.75% du salaire du compagnon Mécanicien en tuyauterie, poseur d'appareils de chauffage, électricien: 1ère année.40% du salaire du compagnon 2èmc année .50% du salaire du compagnon 3ème année.60% du salaire du compagnon 4èmc année.75% du salaire du compagnon Mécanicien de générateurs de tapeur et chaudronnier en construction: * 1ère année.60% du salaire du compagnon 2èmc année.70% du salaire du compagnon 3ème année.80% du salaire du compagnon 4ème année.90% du salaire du compagnon Travailleur en fer structural: 1ère année.70% du salaire du compagnon 2ème année.85% du salaire du compagnon Note: La période complète d'apprentissage est de deux (2) ans et l'employeur peut embaucher un (1) apprenti par trois (3) travailleurs en fer structural employés sur un chantier ou fraction de ce nombre.c) Salaire pour les occupations non prévues: La rémunération de tout salarié exerçant un métier non mentionné dans la cédule de salaires du présent décret, doit être d'au moins $0.15 de l'iicurc de plus que le minimum fixé pour Je journalier dans la zone où le travail est exécuté.d) Salaires des contremaîtres: Le salaire des contremaîtres est de $0.10 l'heure supérieur aux salaires maxima des salariés qu'il dirige si ceux-ci ne dépassent pas le nombre de dix (10); dc $0.20.si ceux-ci dépassent le nombre de dix (10).e) Salaires des entrepreneurs-artisans: Tout entrepreneur artisan qui exécute lui-même un ou des travaux mentionnés dans la juridiction industrielle du présent décret, est considéré comme \"salarié\" du métier exercé et son salaire est fixé conformément au taux de salaire stipulé dans le présent décret./) Salaire des étudiants: Pendant la période des vacances, les étudiants employés comme pointeur ou vérificateur dc matériaux peuvent bénéficier de conditions différentes de celles prévues au présent article (cédule des salaires), pourvu toutefois que ces conditions aient été préalablement approuvées par le Comité paritaire.g) Prime d'équipe: Sur les chantiers utilisant deux (2) ou trois (3) équipes de travailleurs, une prime d'équipe de cinq (5) cents l'heure sera per week Service truck driver.$50.00 $47.50 Watchman (on the job).50.00 47.50 Timekeeper.45.00 42.50 Material checker.50.00 47.50 b) Minimum wages of apprentices: The following percentages shall determine the minimum wage rates of apprentices in the trades hereafter-mentioned : Trades in general: 1st year.40% of journeyman's rate 2nd year.55% of journeyman's rate 3rd year.75% of journeyman's rate Pipe mechanic, steam fitter, electrician: 1st year.40% of journeyman's rate 2nd year.50% of journeyman's rate 3rd year.60% of journeyman's rate 4th year.75% of journeyman's rate Steam mechanic and boilermaker (construction): 1st year.60% of journeyman's rate 2nd year.70% of journeyman's rate 3rd year.80% of journeyman's rate 4th year.90% of journeyman's rate Structural iron worker: 1st year.70% of journeyman's rate 2nd year.85% of journeyman's rate Note: The entire period of apprenticeship shall be two (2) years and employers shall have the right to employ one (1) apprentice to each three (3) structural steel workers or fraction fraction thereof employed on any job.c) Wages for occupations not mentioned: The remuneration of employees whose trade is not mentioned in the wage scale of the present decree shall be at least $0.15 more than the minimum hourly rate of common workers in the zone where the work is executed.d) Foremen's wages: The wage rate of foremen shall be $0.10 higher than the maximum wages of employees under their direction when such employees do not exceed ten (10) in number, or $0.20 higher when they do exceed ten (10) in number.e) Wages of artisan-contractors: Artisan-contractors executing themselves any one of the operations mentioned in the industrial jurisdiction of the present decree, shall be considered as employees of the trade plied and their wages shall be fixed in pursuance of the rates established in the present decree./) Wages of students: During the period of' vacation, students employed as timekeepers or as material checkers may have working conditions different from those established in this article (wage scale) providing the Parity Committee has previously approved such conditions.g) Shift premium: On construction contracts employing two (2) or three (3) shifts of workers, a shift premium of five (5) cents per hour shall be- GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U février 1969, Tome 91, N° 7 payée à tous les ouvriers travaillant entre 7.00 p.m.et 6.00 a.m.h) Avis préalable: Tout employeur ou employeur professionnel désirant renvoyer ou faire chômer un salarié, le jour de travail suivant, doit l'en aviser à la fin de sa journée de travail.A défaut de ce faire, il doit payer à tel salarié qui se rend au lieu du travail à titre de compensation, trois (3) heures de salaire.Cette disposition ne s'applique pas toutefois dans le cas où des salariés travaillant à l'extérieur en sont empêchés par la température.i) Le salaire sera payable en entier deux fois par mois, dans un délai maximum de quinze (15) jours, en monnaie ayant cours au Canada ou par chèque.VI.Vacances payées: Tous les salariés ont droit, à titre de vacances payées, à une rémunération équivalence à 2% du salaire gagné.L'employeur doit remettre cette rémunération à ses salariés à chaque période de paye.VIL Sur les travaux exécutés dans la zone I en vertu d'un contrat forfaitaire, lorsque tel contrat a été signé avant la mise en vigueur dc la présente convention, les salaires payables sont de $0.05 inférieurs à ceux prévus à l'article V.VIII.Dispositions spéciales relatives à la construction de générateurs de vapeur, de chaudières et de réservoirs: Taux horaires minima Chaudronnier en construction, monteur, ébardeur, mateur, brûleur, soudeur et grécur s'y rapportant.$2.20 Mécanicien de générateurs de vapeur.2.20 Aide dans l'un ou l'autre de ces métiers.1.80 Apprenti: La période d'apprentissage est de quatre (4) années et les salaires minima sont les suivants: 1ère année.60% du salaire minimum 2ème année.70% établi pour l'ouvrier 3ème année.80% qualifié.4ème année.90% Pour le métier de chaudronnier en construction, il peut y avoir un (1) aide ou apprenti pour chaque cinq (5) ouvriers qualifiés ou fraction dc ce nombre.Durée du travail: La durée régulière de travail est de quarante (40) heures par semaine réparties entre 8.00 a.m.et 5.00 p.m., du lundi au vendredi inclusivement.Travail supplémentaire: Tout travail exécuté en plus-des heures régulières ou en dehors des limites horaires déterminées est considéré comme du travail supplémentaire et doit être rémunéré au taux de salaire et demi basé sur le taux rqgu-lier ou sur le salaire effectivement payé lorsque ce dernier est plus élevé.Jours de fêtes chômées: Tout travail exécuté le Premier jour de l'An, le Vendredi-Saint, la fête de la Reine, la Saint-Jean Baptiste, le 1er juillet la fête du Travail, le jour d'Actions-de-Grûccs, l'Ascension, la Toussaint, l'Immaculée-Concep-tion, Noël, le dimanche et le samedi après-midi, doit être rémunéré au taux de salaire double basé sur le taux régulier ou sur le salaire effectivement payé lorsque ce dernier est plus élevé.Toutefois, lorsque la célébration de l'un ou l'autre des jours de fêtes ci-haut nommés est fixée par proclamation du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial, selon le cas, ces jours de fêtes doivent être chômés à la date ainsi fixée.paid to all employees working between 7.00 p.m.and 6.00 a.m.h) Notice: Every employer or professional employer who wishes to dispense with the services of an employee the following work day shall so inform that employee before the end of his work day.Should the employer neglect to inform his employee, as above mentioned, and should such employee come back to work the following day, the employer shall pay him a minimum of three (3) hours' pay.This provisions shall not apply when employees whose work is outside are kept from working by untoward weather conditions.i) Wages shall be paid entirely twice a month, within a maximum delay of fifteen (15) days, with Canadian currency or by cheque.VI.Vacation with pay: All employees are entitled to a vacation pay equal to 2% of the wages earned.Employers shall remit s ch vacation pay to their employees together with their pay.VII.In the case of operations earned out in zone I by lump sum contract, when such contract was signed before the coming into force of the present agreement, wages payable shall bo $0.05 lower than those mentioned in article V.VIII.Special provisions relating to ths construction of steam generators, boilers and tmk
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.