Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 27 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1959-06-27, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 91, N° 26 2645 Vol.91, No.26 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Quebec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 27 juin 1959 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné (pie l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1959.Québec, le 20 juin 1959.L'Imprimeur de la Reine, 50831-25-1 l-o RÉDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTERESSES Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces «annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 27th, 1959 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1959.Quebec, June 20th, 1959.RÉDEMPTI PARADIS, 50831 -25-11 -o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 20 Mi GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec.27 juin 1959, Tome 91.X° 3 siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.50866-O P.PRÉNETTE.(E.G.10813-59) Algol Hculty Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mars 1959, constituant en corporation: Jacob Friedman, marchand, Barucll Wcrt/.-berger et Leon A.Vessely, agents, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Algol Realty Limited\", avec un capital total de 840.000.divisé en 2,000 actions ordinaires et 2,000 actions privilégiées, toutes de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1231 ouest, rue Ste-Catherine, suite 215, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.50866 P.FRENETTE.(P.G.12579-59) Ambulance .Métropole Ltée .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959.constituant en corporation: Emile Mecteau.officier de douanes.Fernand Dupras, contremaître, tous deux de Montréal-Nord, et Georges Trudeau, commis de bureau, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un service d'ambulances, sous le non de \"Ambulance Métropole Ltée\", avec un capital total de 825,000, divisé en 2.500 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 11192, rue Lamoureux, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.10855-59) Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1959, constituant en corporation: André-Jean M iron, Douglas (îordon Kettyle, plombiers et John René Poulson, peintre, tous de Lachule.pour les objets suivants: Transiger les affaires d'entrepreneurs en plomberie, chauffage cl réfrigération, sous le nom de \"Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited\", avec un capital total de S50.000.divisé en 500 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachute.district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April.1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10813-59) Algol Really Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec*, bearing date the seventeenth day of March, 1959, incorporating: Jacob Friedman, merchant, Baruch Wertzberger and I^eonA.Vessely, agents, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Algol Realty Limited\", with a total capital stock of 840.000.divided into 2.000 common shares and 2.000 preferred shares all of 810 each.The head office of the company will be at 1231 St.Catherine Street West.Suite 215, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of Mardi.1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.12579-59) Ambulance Métropole Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Emile Mccteau, custums officer, Fernand Dupras.foreman, both of Montreal-North, and Georges Trudeau, office clerk, of Montreal, for the following purposes: Operate an ambulance service, under the name of \"Ambulance Métropole Ltée\".with a total capital stock of $25,000, divided into 2.500 shares of 810 each.The head office of the company will be at 11192 Lamoureux Street.Montreal-North, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of May, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10855-59) Argenteuil Plumbing & Healing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March.1959.incorporating: André-Jean Miron.Douglas Gordon Kettyle.plumbers, and John'René Poulson.painter, all of Lachute, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited\", witli a total capital stock of 850.000, divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Lachute.judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of Mardi.1959.P.FRENETTE, 50S66-O Acting Deputy Attorney General. 2648 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 (P.G.I1487-69) AI tan tic Fclt Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1959.constituant en corporation: Maynard B.Golt, avocat.Marlène Lacroix et Anna Mikula, secrétaires, célibataires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner, acheter et vendre du feutre et produits d'icelui, piqués, textiles et produits d'iceux de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Atlantic Pelt Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1059.L'Assistant -procureur général suppléant, .50866 P.FRENETTE.(P.G.11968-59) Avion Construction Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959, constituant en corporation: John Alper, Ernest Swirsky, marchands, Philip Shapiro, entrepreneur, et Harry Jacob Erdrich, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Avion Construction Co.Inc.\", avec un capital total de 810,000.divisé en 500 actions ordinaires «l'une valeur au pair de S10 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5304 avenue du Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(A.C.11487-59) Altantic Felt Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April.1959, incorporating: Maynard B.Colt, advocate, Marlène Lacroix and Anna Mikula.secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy and sell felt and felt products, quilting, textiles and textile products of every manner and description, under the name of \"Atlantic Felt Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of a par value of S100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, '50866-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11968-59) Avion Construction Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April.1959, incorporating: John Alper, Ernest Swirsky, merchants.Philip Shapiro, contractor, and Harry Jacob Erdrich, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Avion Construction Co.Inc.\".with a total capital stock of SI0,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and 500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 5304 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney ('encrai, this third dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50S66-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.11475-59) Bareli Realty Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mars 1959, constituant en corporation: Isidore M.Bobrove, Edward II.Bcrnfcld, et Jack B.Bobrove, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Bareli Realty Company\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair oie 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(A.G.11475-59) Bareli Realty Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of March, 1959, incorporating: Isidore M.Bobrove, Edward II.Bernfcld and Jack B.Bobrove, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a realty and construction company, under the name of \"Bareli Realty Company\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of a par value of 8100 each and 300 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 -2049 (P.G.11824-59) Bastogne Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: John Herschorn, avocat, Patricia Ilyland, secrétaire, célibataire, et Jack Gruman, dentiste, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'immeubles dans toutes ses diverses spécialités, sous le nom de \"Bastogne Investment Corp.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 5.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 15,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4114 ouest, rue Stc-Catherinc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(A.G.11824-59) Bastogne Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Licutcnant-(Jovernor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1959, incorporating: John Herschorn, Attorney.Patricia Ilyland, Secretary, spinster, and Jack G nun an, dentist, all of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the real estate business in all its various phases, under the name of \"Bastogne Investment Corp.\".with a total capital stock of 820,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 15,000 preferred shares of a par value of SI caeh.The head office of the company will be at \u20221111 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, twenty-sixth this dav of March.1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.11126-59) Beloff Brothers Flooring «X Tile Limited Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Sam BelofF, Harry Ben Beloff.entrepreneurs-parqueteurs, Henry Beloff entrepreneur-couvreur, tous trois de Montréal, et Harry N.Beloff, fabricant, de la ville de Hampstead.pour les objets suivants: Exercer le commerce de parquetage et posage de tuiles de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Beloff Brothers Flooring & Tile Limited\", avec un capital total de 840.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de SIO chacune et 3.900 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50S(i(i P.FRENETTE.(A.G.11120-59) Beloff Brothers Flooring & Tile Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April.1959, incorporating: Sam Beloff, Harry Ben Beloff, flooring contractors, Henry Beloff.roofing contractor, all three of Montreal, and Harry N.Beloff, manufacturer, of the town of Hampstead.for the following purposes: To carry on the business of installation of flooring and tiling of every kind and description, under the name of \"Beloff Brothers Flooring & Tile Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of S10 each and 3,900 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.12010-59) Better Building Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1959, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Nathaniel Liebman.notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Better Building Construction Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de.S10 chacune et 3,600 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866 P.FRENETTE.(A.G.12010-59) Belter Building Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the seventh day of April.1959, incorporating: Abraham Sinister, advocate.Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, law student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, under the name of \"Better Building Construction Ltd.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 100 common shares of 810 each and 3,600 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General. 2650 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 19»9.Tome 91, N° 20 (P.G.11495-59) Better Living Apartments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé pat le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1959, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Natlianiel Licbman, notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Better Living Apartments Inc.\".avec un capital total de $4O,O0O, divisé en 500 actions ordinaires de S10 chacune et 3,500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.12580-59) Bijouterie John Nagy Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: Paul Gélinas, avocat, Claire Loiseau.secrétaire, et Pâquerette Bon net Beaudoin, secrétaire, épouse judiciairement séparée de corps et de biens de J.-Noël Beaudoin, tous de Saintc-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: Faire affaires comme bijoutiers, orfèvres et horlogers, sous le nom de \"Bijouterie John Nagy Ltée\", avec un capital total de 820.000, divi.se en 200 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Suintc-Agathe-des-Monts, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.C.12740-59) Biron & Poirier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mai 1959, constituant en corporation: .hide Gratton, comptable, Françoise Dallaire, secrétaire, Claire Chalifoux, dactylographe.Michèle Dé/.iel, sténodactylographe, toutes trois célibataires majeures, tous quatre de Montréal, et Jcan-B.Fortier, comptable, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de portefeuille (\"holding\"), sous le nom de \"Biron & Poirier Inc.\", avec un capital total de S-10.000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Ix' siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général.le six mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.(A.G.11495-59) Better Living Apartments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Qdcbec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1959.incorporating: Abraham Sinister, advocate, Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, student-at-law, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Better Living Apartments Inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney (\"encrai.(A.G.12580-59) Bijouterie John Nagy Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Paul Gélinas, ad-vacte, Claire Loiseau, secretary, and Pâquerette Bonnet Beaudoin.secretary, wife judicially separate as to bed ami board of J.-Noël Beaudoin.all of Sainte-Agathe-des-Monts, for the following purposes: To carry on business as jewellers, goldsmiths and clock-makers, under the name of \"Bijouterie John Nagy Ltée\".with a total capital stock of 820.000.divided into 200 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Sainte-Agathe-dcs-Monts.judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12740-59) Biron & Poirier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1959, incorporating: Jude Gratton, accountant.Françoise Dallaire.secretary, Claire Chalifoux.typist.Michèle Dé/.kl.steno-typist.all three spinsters of full age of majority, all four of Montreal, and Jean-B.Fortier, accountant, of Westmount.for the following purposes: To carry out the operations of a holding company, under the name of \"Biron & Poirier Inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into -100 shares of 8KM) each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May.1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC DEE ICI.i L GAZETTE, Quebec, June 27th.1059.Vol.91, No.26 2651 (P.G.12678-59) Blondin Automobiles Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1959, constituant en corporation: Léo Hlondin, Dame Ferdinand Blondin, veuve, tous deux garagistes, et Mlle Léonne Hlondin, ménagère, tous de Montréal-Nord, pour les objets suivants : Exploiter le commerce d'automobiles, réparations, pièces de rechange, huiles et de gazoline en gros et en détail, sous le nom «le \"Hlondin Automobiles Limitée\", avec un capital total de 8100,000.divisé en 750 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 2.500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3722.boulevard Gouin, est, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.G.11640-59) Breuvages G.et M.Limitée G.and M.Soft Drinks Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959.constituant en corporation: Clifford George Meek, Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, et John Lawrence McCrory, commis en Loi, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fabricants, embouteil-leurs et distributeurs «le breuvages non-alcooliques de toutes sortes, sous le nom «le \"Breuvages G.et M.Limitée \u2014G.and M.Soft Drinks Limited\", avec un capital total de 81.000.divisé en 100 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint François.Daté «lu bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.11345-59) Castle Investment Corporation Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Iah des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mars 1959, constituant en corporation: Michael Wayne, vendeur, George Wallace, gérant, et Howard Mann, agent, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, sous le nom de \"Castle Investment Corporation\", avec un capital total $40,000.divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le six mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50N00 P.FRENETTE.(A.G.12678-59) Hlondin Automobiles Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1959, incorporating: Léo Blondin.Dame Ferdinand Blondin, widow, both garage-keepers, and Miss Léonne Blondin, housewife, all of Montreal-North, for the following purposes: To operate a business dealing in automobiles, repairs, repair parts, oils and gasoline wholesale and retail, under the name of 'Blondin Automobiles Limitée\", with a total capital stock of 8100.000.divided into 750 common shares of a par value of $100 each, and into 2,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 3722 Gouin Boulevard, East.Montreal-North, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May.1959.P.FRENETTE.5ON00 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11640-59) Breuvages G.et M.Limitée G.and M .Soft Drinks Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April, 1959, incorporating: Clifford George Meek, Guy Ambrose Miller.Bookkeepers, atid John Lawrence McCrory.Law Clerk, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers, bottlers ami distributors of non-alcoholic beverages of all kinds, under the name of \"Breuvages G.et M.Limitée-\u2014G.and M.Soft Drinks Limited\", with a total capital stock of $1,000, divided into 100 shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this third day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11345-59) Castle Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of March.1959, incorporating: Michael Wayne, Salesman, George Wallace, Manager, and Howard Mann.Agent, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name «>f \"Castle Investment Corporation\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of.March.1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General. 2652 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin49f>9, Tome 91, N° 20 (P.G.12750-59) Centre de loisirs de Ste Agathe des Monts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Fernand Ladouceur, courtier d'assurances.Guy Godard, avocat, et Guy Piehé, commerçant, tous de Ste-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: Organiser, orienter, faciliter, encadrer, promouvoir les loisirs en commun de la population de la région de Ste-Agathe-des-Monts et des environs, sous le nom de \"Centre de Loisirs de Ste Agathe des Monts Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers epic la corporation peut posséder est de §350,000.Le siège social de la corporation sera à Sainte-Agathe-dcs-Monts, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.(P.G.11815-59) Chaniplain Propane Gas Corporation La Corporation de Gu/.Propane Chumplain Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1959.constituant en corporation: Pierre Dcssaulles, avocat, Audrey Agar, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal et Bernard Ranger, avocat, de Pointe Claire, pour les objets suivants: Exercer aucun ou plusieurs des commerces qui consistent à faire des recherches, produire, négocier, transporter, emmagasiner, distribuer et manufacturer du pétrole, huiles carboniques, gaz, minerais et autres substances minérales et les produits, sous-produits ou dérivés d'iceux, sous le nom de \"Chaniplain Propane Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Propane Chain-plain\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866 P.FRENETTE.(P.G.11759-59) Charles Alarie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patantes, en date du trente avril 1959, constituant en corporation: Charles Alarie, commerçant' Bertrand Blanchcttc, gérant, et Paul Trudcl, comptable, tous de La Sarre, Abitibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles et autres véhicules et faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Charles Alarie Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions communes de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.(A.G.12750-59) Centre de.Loisirs de Ste Agathe des Monts Inc.\" Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Fernand Ladouceur, insurance broker, Guy Godard, advocate, and Guy Piehé, dealer, all of Sic.Aga-thc-des-Monls, for the following purposes: To organize, guide, facilitate, introduce, promote recreational activities in common for the population of the region of Ste.Agathe-des-Monts and in the vinity thereof, under the name of \"Centre de Loisirs de Ste Agathe des Monts Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $350,000.The head oflice of the corporation will be at Sainte-Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of May 1959.P.FRENETTE, 50861) Acting Deputy Attorney (\"encrai.(A.G.11.S15-59) Chaniplain Propane Gas Corporation La Corporation de Gaz.Propane Chaniplain Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April, 1959, incorporating: Pierre Dcssaulles, advocate, Audrey Agar, secretary, spinster, both of Montreal, and Bernard Ranger, advocate, of Pointe Claire, for the following purposes: To carry on any one or more of the businesses of prospecting for, producing, dealing in, transporting, storing, distributing and manufacturing petroleum, carbon oils, gases, ores and other mineral substances, and the products, byproducts or derivatives thereof, under the name of \"Chaniplain Propane Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Propane Chaniplain\", with a total capital stock of 8-10,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50S66-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11759-59) Charles Alarie Ltde Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April 1959.incorporating: Charles Alarie, dealer, Bertrand Blanchcttc, manager, and Paul Trudcl.accountant, all of La Sarre, Abitibi, for the following purposes: To deal in automobiles and other vehicles, and carry on business as garage-keepers, under the name of \"Charles Alarie Ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company will be at La Sarre, judicial district of Abitibi. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.June 27th, 1969, Vol.91.No.26 2653 Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.G.1.1858-59) Conrad Heating Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ('\u2022té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Abraham Jacob Rosenstein, avocat.Karl Kruger.notaire, tous deux de \"Montréal, et Wilford James Conrad, distributeur, de Greenfield Park, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage, réfrigération, sous le nom de \"Conrad Heating Company\", avec un capital total de 810,000, divisé en 500 actions ordinaires de 810 chacune et 500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 995 ouest, rue Notre-Dame.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50X00 P.FRENETTE.(P.G.12401-59) D.C.L.Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1959, constituant en corporation! Gérard Lapointe, Régent.Gagnon, Berchmans Chénàrd, comptables agréés.Paul-Yvan Marquis, notaire, et Marcelle B.Marquis, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Paul-Yvan Marquis, tous de Rivière-du-Loup, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"D.C.L.Construction Ltée\", avec un capital total de 850.000.divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rivièrc-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.G.11862-59) Denelco Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Lionel Denenberg, Eli Vaffc, tous deux fabricants, de Ville Mont-Royal, et Harry Cohen, marchand, de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Denelco Investment Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11858-59) Conrad Heating Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959.incorporating: Abraham Jacob Rosenstein, advocate.Earl Kruger, notary, both of Montreal, and Wilford James Conrad, distributor, of Greenfield Park, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"Conrad Heating Company\", with a total capital stock of 810,000, divided into 500 common shares of 810 each and 500 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be .at 995 Notre-Dame Street West.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.12104-59) D.C.L.Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1959, incorporaing: Gérard Lapointe, Régent Gagnon, Berchmans Chénard, chartered accountant.Paul-Yvan Marquis, notary, and Marcelle B.Marquis, housewife, wife contractually separate as to property of the said Paul-Yvan Marquis, all of Rivière-du-Loup, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors under the name of \"D.C.L.Construction Ltée\", with a total capital stock of 850.000.divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Rivière-du-Loup.judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of April.1959.P.FRENETTE, 50860 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11802-59) Denelco Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April.1959, incorporating: Lionel Denenberg, Eli Yaffe, both manufacturers, of the Town of Mount Royal, and Harry Cohen, merchant, of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Denelco Investment Corp.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of SI each and 3,600 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General» this second day of April, 1959.P.FRENETTE, 50S06-O Acting Deputy Attorney General. 2654 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 27 juin 1959.Tome 91.N° 2C> (P.C.11474-59) Dorchester Woollens Ltd.Avis est donné (m'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Quéhec «les lettres patentes, en date du douze mars 1959.constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Ix'«> Rosentzyeig et William Levitt, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le confectionneurs et marchands d'articles vestimentaires de toutes sortes et descriptions, tissus textiles et toutes sortes de tissus et produits d'iceux, sous le nom de \"Dorchester Woollens Ltd.\", avec «in capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de 810 chacune et 3.0(H) actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Slontréal.Daté du bureau «lu Procureunjjénéral, le douze mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.11606-59) Elliott Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Quéhec des lettres patentes, en date du vingt mars 1959.constituant en corporation: Avram Harold (îarmaise, comptable agrée, Mortimer Dolman et Philip Borrow, notaires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, sous le nom de \"Elliott Investments Inc.\", avec un capital total «le 810,000.divisé en 1,000 actions «le 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4765 avenue Meridian.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, .50866 P.FRENETTE.(A.G.11474-59) Dorchester Woollens Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day «)f March.1959, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, Queen's Counsel, of Westmount.Ivco Roscntzveig and William Levitt, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers of wearing apparel of all kinds and description, textile fabrics and all kinds of fabrics and fabric products, under the name of \"Dorchester Woollens Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1.000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March.1959.P.FRENETTE.50866-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11666-59) Elliott Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1959, incorporating: Avram Harold (îarmaise, chartered accountant, Mortimer Dolman and Philip Borrow, notaties.all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Elliott Investments Inc.\", with a total capital stock of 810,000.divided into 1.000 shares of 810 each.The head office of the company will be at 4765 Meridian Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.11532-59) Esco Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du seize mars 1959, constituant en corporation: Melvin Salmon, Moses Moscovite!) et Irving L.Adessky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Esco Realties Inc.\", avec un capital total de 85.000.divisé en 5.000 actions ordinaires de Si chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 5165 ouest rue Sherbrooke chambre 303.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le seize mars 1959.i L'Assistant-proeureur général suppléant.50866 P.FRENETTE.(A.G.11532-59) Eseo Realties Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of March, 1959, incorporating: Melvin Salmon, Moses Moscovitch and Irving L.Ades-ky.all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Esco Realties Inc.\".with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of SI each.The head office of the company will be at 5165 Sherbrooke Street west, Room 303.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General. QUEIiFJ' Oil ICI.M.GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2655 (P.G.11773-59) Franklin Woodwork Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date du premier avril 1959.constituant en corporation: Samuel ('hait.Maxwell Shenker, avocats, John Hamilton, secrétaire, tous trois «le Montréal et Harry L.Aronovitch, avocat, «le Côte St-Luc.pour les objets suivants: Exploiter un atelier «le menuiserie et exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Franklin \\Yoo«lwork Inc.\", avec un capital total de $40,000 divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair «le S100 chacune et 100 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «!«\u2022 la compagnie sera à 1535 avenue Hotel «le Ville.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le premier avril 195!).L'Assistant -procureur général suppléant, 50M50 P.FRENETTE.(P.G.12420-59) Gagnon Frères \"Exécutif\" Liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Quéhec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1959, constituant en corporation: Raymond Gagnon, Robert Gagnon et Cyr Blackburn, commerçants, de Chicoutimi, pour les objets suivants: Tenir, moyennant un pourcentage à être fixé chaque année, la comptabilité pour un groupe de magasins et ouvrir un compte «le banque central pour le paiement «les factures «iesdits magasins, sous le nom «le \"Gagnon Frères \"Exécutif\" Ltée\".avec un capital total de $3,000.divisé en 30 actions communes «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire f March, 1959.to incorporate as a corporation without share capital: Arthur McGirr, inspector, Mrs.Dorothy Finigan.housewife, wife contractually separate as to property of William A.Finigan, and Jack A.McNicolI, comptroller, all of L'Abord-à-Plouffe, for the following purposes : The promotion and encouragement of recreational, social and athletic activities among its members and also the promotion and welfare of the children of the community, under the name of \"L'Abord-à-PIoufl'e Community Associai ion\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to he limited, is 875,000.The head office of the corporation will be at L'Abord-à-Plouffe, judicial i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1959.constituant en corporation: Guy Barrette, pharmacien.Claude Biron, Eugène Lafontainc, Henry J.Senk.André Tellier, tous quatre industriels.Normand Champagne, optométriste.Dr Lucien Hénault.dentiste, Dr Ulysse Laferrièrc.médecin, Oneil Lafrenière, courtier en assurances, tous neuf de Berthierville.Gabriel Bcausoleil, et Léo Viens, tous deux industriels, de la paroisse de Berthier, pour les objets suivants: Construire, acheter.louer ou autrement acquérir, et établir, maintenir et exploiter un ou plusieurs terrains de golf, de tennis, de curling ou autres sports, sous le nom de \"Le Club de Golf de Berthier Inc.\u2014 The Berthier Golf and Country Club Inc.\".avec un capital total de $.325.000.divisé en 500 actions communes d'une valeur au pair de $500 chacune et en 150 actions privilégiées de 8500 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Berthierville.distinct judiciaire de Joliette.Daté du bureau «lu Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50S00-O P.FRENETTE.(P.G.12415-59) Le Meuble de Distinction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéhec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1959.constituant en corporation: Jacques Goyette, vendeur.André De-nault.administrateur, et Julien Plouffe, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles et de nouveautés de toutes sortes, sous le nom de \"Ix- Meuble de Distinction Inc.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 300 actions communes de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3990.rue Masson, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50S66-o \"P.FRENETTE.accountant.Y.-Gérard Beaudet.builder, and Claude Girard, notary, all of Montreal, for the following purposes: To group in association the residents of the North of the Island of Montreal; to promote the cultural and social interests of its members and promote and protect the interests of said residents, under the name of \"L'Association des Propriétaires du Nord de Montréal \u2014 North End of Montreal Home Owners Association\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited, is $75,000.The head office of the corporation will be at 2175 Nicolas Pcrrot Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11369-59) Le Club de Golf de Berthier Inc.The Berthier Golf and Country Club Ine.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1959, incorporating: Guy Barrette, pharmacist.Claude Biron.Eugène Lafontainc, Henry J.Senk.André Tellier.all four industrialists.Normand Clnnipagne, optometrist.Dr.Lucien Hénault, dentist, Dr.Ulysse Laferrièrc physician.Oneil Lafrenière.insurance broker, all nine of Berthierville, Gabriel Bcausoleil.and Léo Viens, both industrialists, of the parish of Berthier.for the following purposes: To build, purchase, rent or otherwise acquire and establish, maintain and operate one or more golf courses, tennis courts, curling or other sports, under the name of \"Le Club de Golf de Berthier Inc.\u2014 The Berthier Golf and Country Club Inc.\".with a total capital stock of $325,000, divided into 500 common shares of a par value of 8500 each and into 150 preferred shares of 8500 each.The head office of the company will be at Berthierville, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April.1959.P.FRENETTE.50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12415-59) Le Meuble de Distinction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April.1959.incorporating: Jacques Goyette.salesman.André Dcnault.administrator, and Julien Plouffe, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Le Meuble de Distinction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of §100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 3990 Masson Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th.1959, Vol.91, No.2) 2603 (P.G.12142-59) Leopold S .mar.! Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Lbivdes compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze niai 10.59.constituant en corporation: Mme Marguerite Girard Kmard.veuve, commerçante, Jacques Girard, poseur de tapis, et Mme Yolande Êmard Gervais, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de André Gervais, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tapis et autres couvre-planehers, sous le nom de \"Leopold Êmard Ltée\", avec un capital total de 840,000.divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.\\m siège social de la compagnie sera 2505 rue De Bcllechasse.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.G.12721-59) Les Bétons Préparés Universels Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1959.constituant en corporation: Louis-Philippe Chapdelaine, Darius Forest, Normand Bonin, Rosaire Rivard, tous quatre de Sorcl, Barthélémy Michaud, Emile Michaud et René Michaud, tous trois de St-Baithélemy, tous industriels, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre, importer et exporter et généralement faire le commerce de béton préparé (\"ready-mix\"), du béton, du ciment et de leurs sous-produits, sous le nom de 'Tes Bétons Préparés Universels Ltée\".avec un capital total de 8100,000.divisé en 300 actions communes d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 700 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Ixi siège social de la compagnie sera à Saint-Barthélémy, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 50800-O P.FRENETTE.(P.G.12499-59) Les Entreprises de Beance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Louis Bolduc, Henri-Louis Busqué, industriels, Laurent Mathieu, peintre, tous trois de Beauceville-Est, et Henri-Ixiuis Thibodeau, cultivateur et menuisier, de St-François-Ouest.pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Entreprises de Beauce Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beauceville-Est, district judiciaire de Beauce.(A.G.12142-59) Leopold Éniurd Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May.1959, incorporating: Mrs.Marguerite Girard Emard, widow, merchant, Jacques Girard, carpet-layer, and Mrs.Yolande Êmard Gervais, housewife, wife contractually separate as to property of André Gervais, and duly authorized by him for these presents, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in carpets and in other floor-coverings under the name of \"Leopold Êmard Ltée\", with a total capital stock of 840,000.divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be'at 2505 De Belleehasse, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12721-59) Les Bétons Préparés Universels Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May.1959, incorporating: Louis-Philippe Chapdelaine.Darius Forest, Normand Bonin, Rosaire Rivard, all four of Sorel, Barthélémy Michaud.Emile Michaud.and René Michaud, all three of St.Barthélémy, all industrialists, for the following purposes: To manufacture, buy, sell, import, export and-generally carry on the business of Ready-Mix concrete, concrete, cement and the by-products thereof, under the name of \"Les Bétons Préparés Universels Ltée\".with a total capital stock of 8100.000.divided into 300 common shares of a per value of 8100 each and 700 preferred shares of a per value of 8100 each.The head office of the company will be at Saint-Barthélémy, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May.1959.P.FRENETTE, 50SG0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12499-59) Les Entreprises de Beauce Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April, 1959.incorporating: Louis Bolduc, Henri-Louis Busquc.industrialists, Laurent Mathieu, painter, all three of Beauceville-Êast.and Henri-Louis Thibodeau.farmer and carpenter, of St.François West, for the following purposes: To carry on the business of builders and general building contractors, under the name of \"Les Entreprises de Beauce Inc.\", with a total capital stock of 840.000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at.Beauceville-East, judicial district of Beauce. 2664 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1969, Tome 91, N° 21 Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General, sept avril 1959.this twenty-seventh day of April.1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, I'.FRENETTE, 50866-O P.FRENETTE.50S00 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13049-59) Les Habitations St-Sulpiee Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Quéhec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéhec des lettres patentes, en date du vingt-deux niai 1959, constituant en corporation: Victor Barbeau, économiste, de West mount.Romer Gauthier, Gérard Poitras, gérants, de St-Léonard-de-Port-Maurice (Laval), Char-les-A.Jobin, Jean-Paul Brodeur, gérants, de Montréal, et François-Albert Angers, économiste, de St-Lambert, pour les objets suivants: Acquérir et exploiter les immeubles connus sous le nom de \"Domaine St-Sulpice\", sous le nom de \"Les Habitations St-Sulpice Inc.\", avec un capital total de 8500,000, divisé en 10,000 actions classe \"A\" d'une valeur au pair de 85 chacune, 8,000 actions classe \"B\" d'une valeur au pair de $50 chacune et en 1,000 actions classe \"C\" d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux niai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O I».FRENETTE.(A.G.13049-59) Les Habitations St-Sulpiee Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May.1959.incorporating: Victor Barbeau, economist, of Westmount.Romer Gauthier, Gérard Poitras, managers, of St-Léonard-de-Port-Maurice (Ixival), Charles-A.Jobin, Jean-Paul Brodeur, manager, of Montreal, and François-Albert Angers, economist, of St-Lambert, for the following purposes: To acquire and operate real estate under the name of \"Domaine St-Sulpice\", under the name of \"Les Habitations St-Sulpice Inc.\", with a total capital stock of $500,000.divided into 10,000 class \"A\" shares of a par value of $5 each.8,000 class \"B\" shares of a par value of $50 each and into 1,000 class \"C\" shares of a par value of 850 each.¦ The head office of the.company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of May.1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12099-59) Les Immeubles Lebon Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: Jean-Guy Mathers,constructeur,de St-Eustache-sur-le-Lac, Luc Léveillé, notaire, et Gertrude Lemay-, secrétaire, tous deux de St-Eutache, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Lebon Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions communes de 81 chacune et en 39.000 actions privilégiées de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Eustaehe-sur-Ic-Lae, comté de Deux-Montagnes, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.(A.G.12699-59) Les Immeubles Lebon Limitée / Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May.1959.incorporating: Jean-Guy Mathers, builder, of St-Eustache-sur-le-Lac.Luc Léveillé, notary, and Gertrude Lemay, secretary, both of St-Eustache.for the following purposes: The carry on a business dealing in real estate under the name of \"Ix-s Immeubles Lebon Limitée\", with a total capital stock of 840.000.divided into 1,000 common shares of 81 each and into 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Saint-Eustache-sur-le-Lac, county of Two-Mountains, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May.1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12697-59) Les Immeubles Monpré Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixn des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: Jean-Guy Mathers, constructeur, de St-Eus-tache-sur-le-Lac, Luc Léveillé.notaire, et Mlle Gertrude Lemay, secrétaire, tous deux de St-Eustache, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Monpré Limitée\", avec un capital total de $40.000.divisé en 1.000 actions communes de $1 chacune et en 39.000 actions privilégiées de $1 chacune.(A.G.12097-59) Les Immeubles Monpré Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May 1959.incorporating: Jean-Guy Mathers, builder, of St.Eustache-sur-le-Lac, Luc Léveillé, notary, and Miss Gertrude Lemay.secretary, both of St.Eustache.for the following purposes: To deal in immoveables, under the name of \"Les Immeubles Monpré Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of $1 each and 39.000 preferred shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, So.26 2665 Le siège social de la compagnie sera à Saint-Eustache-sur-le-Lac.comté de Deux-Montagnes, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le onze 1959.L'Assistaut-procurcur général suppléant.50866-o 1'.FRENETTE.(P.G.12480-59) Les I.ni-ir.- du Coeur Immaculée de Marie Ste-Thérèse Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Bernard Dorais, de Stc-Tliérèsc-de-Blainvilli', Michel Côté, de Rose-mère, tous deux avocats, et .Julien Bélair, gérant, de Ste-Thérèse-de-Blainvillc, pour les objets suivants: Établir et diriger un centre de loisirs, sous le nom de \"Les Loisirs du Cœur Immaculé de Marie Ste-Thérèse Inc.\".I/c montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 16,000.Le siège social de la corporation sera Boulevard Desjardins, Sainte-Thérèsc-di'-Blainville, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt sept avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508GG-o P.FRENETTE.(P.G.11434-59) I>es Placements Nemo Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mars 1959, constituant en corporation: Isidor Raymond Hait, Avrom Podbere et Leonard H.Wisse, tous notaires, de Montréal, pour les objets suivants: ^ Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Les Placements Nemo Inc.\", avec un capital total de 810,000.divisé en 1,000 actions de 810 chacune.Le siège social rie la compagnie sera 4950 Chemin de la Reine Marie, chambre 425.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.12493-59) Les Transports ABC.Limitée Avis est donné (pi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Ephrein Dufresne, Victor Racine, entrepreneurs, Charles-Ludger Harvey, plombier, Frédéric Achard, électricien,.tous quatre de Jonquière, et Rock Tremblay, marchand, de Kénogami, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport et de camionnage, sous le nom de \"Les Transports ABC.Limitée\", avec un capital total de 840.000, The head office of the company will be at Saint Eustache-sur-le-Lac, county of Two Mountains judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of May.1959.P.FRENETTE, 50X06 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12480-59) Les loisirs du Coeur Immaculée de Marie Ste-Thérèse Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April 1959, to incorporate as a corporation without share capital : Bernard Dorais, of Ste.Thérèse-dc-Blainville.Michel Côté, of Roscmère, both advocates, and Julien Bélair, manager, of Ste.Thérèse-dc-Blainville.for the following puposes: To establish and manage a recreational center, under the name of \"Les Loisirs du Cœur Immaculé de Marie Ste-Thérèse Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 85,000.The head office of the corporation will be on 1 )esjardins Boulevard, Saintc-Thérèse-de-Blain-ville, judicial district of Terrebonn.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11434-59) Les Placements Nemo Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of March.1959, incorporating: Isidor Raymond Hart, Avrom Podbcre and Leonard H.Wisse, all notaries, of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Les Placements Nemo Inc.\", with a total capital stock of 810,000.divided into 1.000 shares of S10 each.The head office of the company will be at 4950 Queen Mary Road.Suite 425.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy-Attorney General.(A.G.12493-59) Les Transports ABC.Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April 1959, incorporating: Ephrem Dufresne.Victor Racine, contractors, Charlcs-Ludger Harvey, plumber, Frédéric Achard, electrician, all four of Jonquière.and Rock Tremblay, merchant, of Kénogami, for the following purposes: To carry on business as a forwarding and trucking company, under the name of \"lies Transports ABC.Limitée\", with a total capital 2666 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, \\° > > divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du hureau du Procureur général, le vingt-sept, avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.G.12590-59) Lionel Arsenaull Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéhec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: Lewis Cannon, avocat, de Sillery, Janine Sou-lard, de Quéhec, et I/Oiiise Portier, de Québec-Ouest, toutes deux secrétaires, célibataires, poulies objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Lionel Arsenault Inc.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Ix; siège social de la compagnie sera à Sillery.district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50806-O P.FRENETTE.(P.G.12212-59) Marjuu Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1959.constituant en corporation: Marvin Ribaek.Jack Lightstonc, et Harohl Asheninil, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom «le \"Marjan Investment Corp.\", avec un capital total «le 840,000.divisé en 2,000 actions ordinaires «le $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 311 Carré d'Youville, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général.4 ¦ ireuf avril 1959.L'Assistant-proeureur général supplé ut.50866 P.FRENETTE.(P.G.12680-59) Marland Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date «lu huit mai 1959.constituant en corporation: Joseph Shapiro.Benjamin Robinson, tous deux avocats et conseils en loi «le la Reine, «le Westmount.Jonathan J.Robinson, avocat.Ethel Yusscin.secrétaire, et Jean McFarlane, dactylo, toutes deux filles majeures, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais, et les négocier sous le nom de \"Marland Mines Ltd.\" (No Per- stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of April, 1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12590-59) Lionel Arsenault Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, bearing date the first day of May 1959.incorj>orating: Lewis Cannon, advocate, of Sillery.Janine Soulard, of Quebec, and Louise Fortier, of Quebec-West, both secretaries, spinsters, for the following put poses: To carry on the business of builders ami general building contractors, under the name of \"Lionel Arsenault Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of 810 each and 3.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of May 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12212-59) Marjan Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April.1959.incorporating: Marvin Riback.Jack Lightstonc and Harold Asheninil.all advocates, of Montreal, for the billowing purposes : To carry on the business of an investment company, under the name of \"Marjan Investment Corp.\".with a total capital stock of $40.000.«livi«lcd into 2,000 common shares of 810 each ami 2.000 preferred-shares of 810 each.The head office of the company will be at 311 Youville Square, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.' s r (A.G.120S0-59) Marland Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May.1959, incorporating: Joseph Shapiro.Benjamin Robinson, both advocates and Queen's Counsels, of Westmount, Jonathan J.Robinson, advocate, Ethel Yussein, secretary, and Jean McFarlane, typist, both filles majeures, all three of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines ami minerals ami t«> deal with the same, under the name of \"Marland Mines Ltd.\" (No Personal Liability), QUEHEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, June 27th, 1909, Vol.91, No.26 sonal Liability), avec un capital total de $5.000.-000, divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.\u2022 Le siège social de la compagnie sera à 1010 ouest, rue Sherbrooke.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50860 P.FRENETTE.(P.G.10013-59) Marshall Bros.Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la I/>i «les compagnies de Québec, il a été accordé par l«- Lieutenant-gouverneur «le la province «le Quéhec des lettres patentes, en date «lu premier avril 1959.constituant en corporation: Kenneth Alphonso Marshall, préposé aux services «le Pullman, «h- Montréal, Albert Elphinstone Holloway, professeur, «le Ville LaSalle.et .lames Earle Marshall, marchand, de Westmount.pour les objets suivants: Fabriquer, négocier et en général faire le commerce de toutes sortes équipement motorisé, pièces et accessoires, sous le nom «le \"Marshall Bros.Inc.\".avec un capital total de 85.000, divisé en 50 actions de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.12016-59) Metro Chesterfield Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en date du sept avril 1959, constituant en corporation: Monty Moss, gérant, Shirley Guss Moss, teneuse de livres, épouse séparée de biens dudit Monty Moss, et Leah Radbord Silverman, veuve, finisseuse, tous de Montréal, pour les objets suivants : Fabriquer et faire le commerce de meubles, boiserie, et toutes sortes d'articles «le ménage, fournitures et outillage, sous le nom «le \"Metro Chesterfield Ltd.\", avec un capital total «le $20,000, «livisé en 2.000 actions ordinaires de $1 chacune «le 1.800 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le sept avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant.50800 P.FRENETTE: (P.G.11964-59) Mikron Realties Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Quéliec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959.constituant en corporation: Ann Druzin, secrétaire, fille majeure, «le Lon-gueuil, Mary Gaffney, secrétaire, fille majeure, with a total capital stock «>f $5,000,000, divided into 5,000,000 common shares of 81 each.The shareholders «>f the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office «>f the company will be at 1010 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 50S66-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10013-59) Marshall Bros.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first f Westmount, for the following purposes: To manufacture, trade ami generally deal in all kinds of automotive equipment, parts and accessories, under the name of \"Marshall Bros.Inc.\".with a total capital stock of 85.000, divided into 50 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April.1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12010-59) Metro Chesterfield Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of Ap.il.1959.incorporating: Monty Moss, manager.Shirley Guss Moss, Bookkeeper, wife separate as to property of the said Monty Moss, and Leâh Radbord, Silverman, widow.Finisher, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, woodwork and all kinds of household articles, furnishings and equipment, under the name of \"Metro Chesterfield Ltd.\".with a total capital stock of $20,000.divided into 2.000 common shares of SI each and 1.800 preferred shares of $10 each.The head office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day t)f April, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11904-59) Mikron Realties Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, bearing date the third day of April, 1959.incorporating: Ann Druzin.secretary, spinster of full age of majority, of Longueuil, Mary Gaffney, secretary, spinster of full age of 2668 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959.Tome 91, N° 2-i et Gerald ('harness, avocat, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de compagnie de placements, sous le nom de \"Mikron Realties Corp.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4 est, rue Notre-Dame, chambre 504, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50S06 P.FRENETTE.majority, and Gerald ('harness, advocate, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Mikron Realties Corp.\".with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at 4 Notre-Dame Street East, room 504.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of April, 1959.P.FRENETTE.50866-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.11005-59) Milton Kantcr Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1959.constituant en corporation: Harold Lande, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount.Milton Kanter, marchand, de Hampstead.Harry Luxton.gérant.d'Outrc-mont, et.Joseph S.Caplan, avocat, de Montréal, pour les objets suivants! Fabriquer, vendre, distribuer, importer, exporter ou autrement faire le commerce de meubles et toutes sortes de fournitures de ménage, de bureau ou de commerce, sous le nom de \"Mil-ton Kanter Ltd.\", avec un capital total de 840,-000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair'de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50800 P.FRENETTE.(A.G.11005-59) Milton Kanter Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1959, incorporating: Harold Lande, attorney and Queen's Counsel, of West-mount.Milton Kanter, merchant, of Hampstead, Harry Luxton, manager, of Outremont, and Joseph S.Caplan, advocate, of Montreal, for the following purposes: To manufacture, sell, distribute, import, export, or otherwise deal in furniture and all kinds of household, office or commercial furnishings, under the name of \"Milton Kanter Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 500 common shares of a par value of 810 each and 3.500 preferred shares of a par value of $10 each.fjj The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.11843-59) Modan Taxi Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: Bernade Charette, Pierrette Grenier et Huguette Lessard, toutes secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général de service de taxis, sous le nom de \"Modan Taxi Ltd.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 40 actions ordinaires de 8100 chacune et 3(50 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50800 P.FRENETTE.(A.G.11843-59) Modan Taxi Ltd.Notice is hereby given that under Part I of* the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1959, incorporating: Bernade Charette, Pierrette Grenier and Huguette Lessard, all secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To generally carry on a taxicab business, under the name of \"Modan Taxi Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided'into 40 common shares of $100 each and 360 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1959.P.FRENETTE, 508G0-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12599-59) Moon Valley Lumber Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: Charles-E.Boily, de Montmorency, Jean-M.Morissette et André Villeneuve, de Québec, tous avocats, pour les objets suivants: (A.G.12599-59) Moon Valley Lumber Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Charles-E.Boily, of Montmorency, Jean-M.Morissette and André Villeneuve, of Quebec, all advocates, for the following puposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91.So.26 2069 Faire l'exploitation «les forêts et le commerce de marchands de bois dans toutes ses spécialités, et exploiter des moulins à bois de toutes sortes, sous le nom de \"Moon Valley Lumber Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 210 actions communes de SI00 chacune et en 190 actions privilégiées de Si00 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1998, boulevard St-Joseph, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50800-o P.FRENETTE.(P.G.12443-59) Nominingiie Transport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I/>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: .lean-Paul St-Ixniis.Marcel Belleville, avocats, et Rita Gevry, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des entreprises de camionnage et généralement faire le transport «le marchandises «le toutes sortes, sous le nom de \"X«>miningue Transport Ltée\", avec un capital total siège social «le la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire «le Sagucnay.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-«plâtre avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50860-o P.FRENETTE.(P.G.12504-59) Norman Specialties Inc.Avis est donné «m'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation: Roger DeSève, gérant, «le Montréal, Rosaire Desnoyers, marchand, et Mme Renée To carry out lumbering operations and carry on, in all its branches, and operate lumber-mills t)f all kinds, the business of lumber merchants under the name of \"Moon Valley Lumber Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 210 common shares of 8100 each and 190 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at 1998 St.Joseph Boulevard, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12443-59) Nominingiie Transport Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April.1959, incorporating: Jean-Paul St-Louis, Marcel Belleville, advocates, and Rita Gevry, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To operate trucking enterprises ami t«» generally carry the transportation «»f merchandise of all kinds, under the name of \"Nominingiie Transport Ltée\", with a total capital stock of 810.000.divided into 100 common shares of 8100 each.The head office of the company will re at Noininingue, judicial district of Libelle.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of April.1959.P.FRENETTE.50S00 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12426-59) Norbloc Ltée Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April 1959.incorporating: Yves-A.Rioux, notary.Paul Simard, manager, and Madeleine Morissettc.secretary, fille majeure, all of Sept-Iles.for the following purposes: To carry on the business of and deal in cement and the by-products thereof, cement blocks, tiles, artificial stones and other products similar thereto, under the name of \"Norbloc Ltée\", with a capital divided into 400 shares without nominal or par value, and the amount with which the company shall commence its operations is 82.000.The head office «)f the company will be at Sept-Iles, judicial district t>f Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of April 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12504-59) Norman Specialties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April.1959.incorporating: Roger DeSève, manager, of Montreal.Rosaire Dcs-noyers, merchant, and Mrs.Renée Patenaude 2670 GAZETTE GEE ICI ELLE DE QUÉHEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 Patenaude Desnoyers, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Rosaire Desnoyers, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, de Pont-Vian, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles, nouveautés, d'appareils de reproduction sonore et de communication, articles de bureau «le toutes sortes, jouets, quincaillerie, vitres, accessoires électriques, tissus, ainsi que du bois et autres matériaux, sous le nom de \"Norman Specialties Inc.\", avec un capital total «le $40,000, divisé en 3,000 actions communes «le $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-hint avril 1050.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.(P.G.12005-50) N.R.W.Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date «lu huit avril 1959.constituant en corporation: Sydney Nowa.Donald Walker, tous deux fabricants, de Montréal, et Louis Rosen, comptable agréé, de St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, immeubles, placements et portefeuille, sous le nom de \"N.R.W.Enterprises Ltd.\".avec un capital total de $40.000, divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 2.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune.Ix; siège social «le la compagnie sera à 4445 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.11472-59) Omega Motors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du douze mars 1959, constituant en corporation: Melvin Leonard Rothman, de Westmount, Boris Joseph Berbrier, «le Montréal, Godfroy Marin, de Pointe Claire, tous trois avocats, et Dorothea Calver, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce général de toutes sortes d'automobiles et exploiter, gérer des garages, sous le nom de \"Omega Motors Ltd.\".avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5402 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal; Daté du bureau «lu Procureur général, le douze mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866 P.FRENETTE.(P.G.12421-59) Orner Borret & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Desnoyers, housewife, wife contractually separate as to property of the said Rosaire Desnoyers, ami duly authorized by him for the purposes therein, of Pont-Viau.for the following purposes: To deal in furniture, novelties, sound recording .and communication apparatus, office supplies, of all kinds, toys, hardware, window-panes, electrical applicances, fabrics, as well as wood and other materials, under the name of \"Norman Specialties Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each ami 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney («encrai, this twenty-eighth day of April.1959.P.FRENETTE, 50S00 Acting Deputy Attorney General: (A.G.12005-59) N.R.W.Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of April, 1959, incorporating: Sydney Nowa.Donald Walker, both manufacturers, of Montreal, and Louis Rosen, chartered accountant, of St.Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a land, real estate, investment ami holding company, under the name of \"N.R.W.Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 200 preferred shares of a par value of $100 each ami 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 4445 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of April, 1959.P.FRENETTE.50866-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11472-69) Omega Motors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of March, 1959, incorporating: Melvin Leonard Rothman, of Westmount, Boris Joseph Berbrier, of Montreal, Godfroy Marin, of Pointe Claire, all three advocates, and Dorothea Calver, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To generally deal in all kinds of automobiles and to operate and manage garages, under, the name of \"Omega Motors- Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 5402 Sherbrooke Street West.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of March, 1959.P.FRENETTE, 508GG-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12421-59) Omer Borret & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th.7.9.59, Vol.91, No.£0 2071 -c- été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la lieen issued by the Lieutenant-Governor of the province de Quéhec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty - du vingt-quatre avil 1959, constituant en corpo- fourth day of April, 1959, incorporating: Gilles ration: Gilles Filion, avocat, Glaire Portier, sténo- Filion, advocate, Claire Forticr, stenographer, graphe, célibataire majeure, tous deux de Mont- spinster of full age, both of Montreal, and Gus- réal, et Gustave Monette fils, avocat, de Préville, tave Monette, son, advocate, of Préville, for the pour les objets suivants: following purposes: Exercer le commerce d'entrepreneurs géné- To carry on a business of general contractors, raux, constructeurs et menuisiers, sous le nom de builders and carpenters, under the name of \"Orner Borret & Cie Ltée\", avec un capital total \"Orner Borret & Cie Ltée\", with a total capital de $40,000, divisé en 4.000 actions de $10 chacune, stock of $40,000.divided into 4,000 shares of $10 each.Ixî siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will l>e at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt- Dated at the office of the Attorney General, quatre avil 1959.this twenty-fourth day of April, 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, P.FRENETTE, 50800-O P.FRENETTE.50866 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11830-59) Paris Star Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1959.constituant en corporation: André Veres, fabricant.Gregory Charlap, Arthur Shulman et Max Slapack.tous trois avocats tous «le Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer .et faire le commerce général de grossistes et détaillants de soie, cotons, laine, filés, lin et autres substances fibreuses aussi bien que fils, filaments, draps, tissus et autres textiles, sous le nom «le \"Paris Star Inc.\".avec un capital total de $40,000, «fivisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées cates.and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate jus to property of Marcel LeBlanc, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business «»f a real estate and development company, under the name'of \"President Development Corp.\".with a total capital stock of $5.000, divided into 5.000 common shares of $1 eaeh.The head office of the company will be at 0720 Jeanne Mance Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General. QUEHEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2073 (P.G.14736-58) Quebec Epilepsy League, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Mlle Mary E.Covert, professeur de musique, Mlle Dora Connu, sténographe, et Laurette Coutu, ménagère, épouse commune en biens de Louis Winer, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fournir des prospectus afin de propager les informations concernant la nature et les effets de Pépilepsie et les moyens d'aider les épilepti-ques à participer aux activités sociales, récréatives et éducatives, sous le nom de \"Quebec Epilepsy League, lue\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière (pie la corporation peut posséder est 8150,000 ou 10 acres de terrain.Le siège social de la corporation sera à 3010 rue Durocher, appartement 18, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50806 P.FRENETTE.(A.G.14736-58) Quebec Epilepsy League, Inc.Notice is hereby gû/en that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1959.to incorporate as a corporation without share capital: Miss Mary E.Covert, music teacher.Miss Dora Connu, stenographer, and Laurette Coutu, housewife, wife common as to property of Louis Winer, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of Montreal, for the following purposes: To provide programmes to disseminate information concerning the nature and effects of epilepsy and to assist epileptics to participate in social, recreational and educational activities, under the name of \"Quebec Epilepsy League.Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is 8150,000 or 10 acres.The head office of the corporation will l>e at 3010 Durocher Street, Apt.18, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50S00-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12292-59) Raymond Hardware Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>cc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation: Marc-E.Cordeau, avocat, de Longueuil, Fernand Raymond, administrateur, de St-Michcl, Jacques Pilon, avocat.Julienne Des Rochers, secrétaire, tous deux de Montréal, et Luce Patenaudc, avocat, de Caitierville, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quincailliers, sous le nom de \"Raymond Hardware Inc.\", avec un capital total de 810,000.divisé en 10.000 actions communes de 81 chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7-100, lOième Avenue, Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50806-o P.FRENETTE.(A.G.12292-59) Raymond Hardware Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April, 1959.incorporating: Marc-E.Cordeau, advocate, of Longueuil, Fernand Raymond, administrator, of St-Michel.Jacques Pilon, advocate.Julienne Des Rochers, secretary, both of Montreal, and Luce Patenaude, advocate, of Cartierville, for the following purposes: To carry on a business as hardware dealers under the name of \"Raymond Hardware Inc.\".with a total capital stock of 840.000, divided into 10,000 common shares of 81 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e at 7400, 19th Avenue, Saint-Michel, judicial district of Montreal.\u2022 * Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12089-59) Ray's Service Station Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ee des lettres patentes, en date du treize mai 1959, constituant en corporation: Marcel Girard, garagiste, Anne-Marie Guénette Girard, ménagère, épouse séparée de biens d- dit Marcel Girard, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Raymond Gauthier, garagiste, et Cécile Forget Gauthier, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Raymond Gauthier, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Morin Heights, pour les objets suivants: ' (A.G.12089-59) Ray's Service Station Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1959, incorporating: Marcel Girard, garage-keeper, Anne-Marie Guénette Girard, housewife, wife separate as to property of the said Marcel Girard and duly authorized by him for these purposes, Raymond Gauthier, garage-keeper, ami Cécile Forget Gauthier, housewife, wife separate as to property of the sai«l Raymond Gauthier, ami duly authorized by him f«>r these present purposes, all of Morin Heights, for the following purposes: 267-1 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, Ne 20 Exercer le commerce d'automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom «le \"Ray's Service Station Ltd.\".avec un capital total «le $40.000.divise en 4.000 actions «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Morin Heights, district judiciaire «le Terrebonne.Daté du bureau «lu Procureur général, le treize mai 1959.I 'Assistant-procureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.10589-59) Rideau Metals & Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959.constituant en corporation: Arthur I.Bronstein.William I.Miller, tous deux de Montréal, et Morton Bell, de St-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le marchands «le rebuts, acier et métal, sous le nom «le \"Rideau Metals & Equipment Ltd.\".avec un capital total de $40,000.divisé en 200 actions ordinaires ce $100 chacune et 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, disti ict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.To carry on a business dealing in automobiles and to carry on business as garage-keepers, inuler the name of \"Hay's Service Station Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divitled into 4,000 shares of $10 each.The hca«l office of the company will be at Morin Heights, jiulicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav «>f May, 1959.P.FRENETTE, 508(56 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10589-59) Rideau Metuls & E«]uipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April.1959.incorporating: Arthur I.Bronstein, William 1.Miller, both of Montreal, and Mort«)ti Bell, of St.Laurent, all a«lvocates, for the following purposes: To earry on business as scrap, steel and metal merchants, under the name of \"Ruleau Metals & Equipment Ltd.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date«l at the office of the Attorney General, this third day of April.1959.P.FRENETTE, 50860-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11729-59) Rima Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt mars 1959, constituant en corporation: Rita Berman, administrateur, secrétaire, fille majeure.Samuel Leon Mendelsohn,' avocat et conseil en loi de la Reine, tous deux de Westmount, i/co Posent zveig et Stanley Taviss, tous deux avocats, de Montréal, pour les objets suivants : Paire le commerce «le confection pour dames et hommes et tous autres articles s'y rapportant, lainages et soies et toutes autres marchandises connexes, sous le nom de \"Rima Ltd.\", avec un capital total «le 840.000.divisé en 1,000 actions ordinaires «le 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppk'-ant, 50800 P.FRENETTE.(P.G.12423-59) Rioux & Frères Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de.Québec, il a été acconlé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1959.constituant en corporation: Yves-A.Rioux.notaire.Paul Simard.gérant, et Madeleine Morissettc.secrétaire, fille majeure, tous de Sept-Iles, pour les objets suivants: (A.G.11729-59) Rima Ltd.Notice is hereby .given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twentieth day of March, 1959, incorporating: Rita Berman, executive, secretary, unmarried of the full age of majority, Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, both of Westmount, Leo Rosentzveig ami Stanley Taviss, both advocates, of Montreal, for the following purposes: To deal generally in la lies' and men's clothing attire and all other things pertaining to same and in woollens and silks and other articles related thereto, under the name of \"Rima Ltd.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of March.1959.P.FRENETTE, 50S(5(5-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12423-59) Rioux & Frères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1959.incorporating: Yves-A.Rioux.notary.Paul Simard, manager, and Madeleine Morissettc, secretary, spinster, all of Sept-Iles, for the following purposes: QUEBEC DEE ICI AL GAZETTE, Quebec.June 27th.I9Ô9.Vol.91, So.23 2(575 Exercer dans toutes ses spécialités le commerce d'entrepreneurs de pompes funèbres, sous le nom de \"Rioux & Frères Inc.\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de §3.500.I/1 siège social de la compagnie sera 70.rue Jean Rioux.Trois-Pistolcs.district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1059.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.12543-59) R.Laflummc & Frère Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéhec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéhec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959.constituant en corporation: Severin Lâchapelle, avocat.Lucien Racine, comptable agréé, et Gilles Biais, étudiant, tous de Québec, pour les objets suivants: Fabriquer, acheter, vendre, installer, importer et exporter et faire le commerce de portes, fenêtres et autres ouvertures, sous le nom de \"R.La Ha m me & Frère Inc.\".avec un capital total de $00.000.divisé en 000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Apollinaire,, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508G6-O P.FRENETTE.(P.G.12318-59) Robert Frenette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1950, constituant en corporation: Paul St-Onge, électricien.Robert Frenette.entrepreneur-peintre, et LouisetteSt-Onge, ménagère, épouse séparée de biens dudit Robert Frenette.tous des Trois-Rivières.pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en peinture et en construction, sous le nom de \"Robert Frenette Inc.\", avec un capital total de 840.000.divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 5080G-O P.FRENETTE.(P.G.12490-59) Roscmount Welding Contractors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Marcel Hamelin.notaire, Jean-Claude Bureau, avocat, et Thérèse David, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: To carry on in all its specialties, business as general undertakers under the nan*- of \"Rioux & Frères Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value and into 300 preferred shares of 8100 each, and the amount with which the company shall start its operations shall be $3.500.The head office of the company will be at 70, Jean Rioux Street.Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of April.1959.P.FRENETTE.50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12543-59) R.Laflamme & Frère Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April.1959.incorporating: Severin Laeha|h>lle.advocate, Lucien Racine, chartered accountant, and Gilles Biais, student, all of Quebec, for the following purposes: To manufacture, purchase, sell, install, import and export and carry on the business which deals in doors, windows and in other openings, under the name of \"R.Laflamme & Frère Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 000 common shares of a par value of 8100 each.The head office of tee company will be at Saint-Apollinaire, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of April.1959.P.FRENETTE, 508(56 ' Acting Deputy Attorney General.(A.G.12318-59) Robert Frenette Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twentieth day of April.1959.incorporating: Paul St-Onge, électricien.Robert Frenette.painter-contractor, and Louisette St-Onge.housewife, wife separate as to property of the said Robert Frenette.all of Trois-Rivières.for the following purposes: To carry on a business as contractors in painting and construction, under the name of \"Robert Frenette Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each, and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières.judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of April.1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12490-59) I»o-(-ni(111111 Welding Contractors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April 1959.incorporating: Marcel Hamelin, notary, Jean-Claude Bureau, advocate, and Thérèse David, secretary, all of Montréal, for the following purposes: 2676 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, A70 2i Exercer le commerce i des compagnies de Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéhec des lettres patentes, en date du treize mai 1959, constituant en corporation: Clovis Ares, industriel, Rosaria Trottier, ménagère, épouse séparée de biens dudit Clovis Ares, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Ville Mont-Royal, et Marcel Bertrand, notaire, de Verdun, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"R.Trottier Ltée\", avec un capital total de 82.000.divisé en 200 actions de $10 chacune.Ixî siège social de la compagnie sera 8014, avenue de l'Ept'e, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.11539-59) Su m.Ira Land Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mars 1959, constituant en corporation: Abraham Peiner, Albert Marcus, Isidore Reuben Praz/off, avocats, et Myrna Katz, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, poulies objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"San«lra Land Development Corp.\", avec un capital total de $120,000, divisé en 12,000 actions ordinaires de $1 chacune et 108,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le dix-sept mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50800 P.FRENETTE.(P.G.12199-59) Seven Pillars Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date «lu neuf avril 1959, constituant en corporation: Melvin Salmon, de la ville Cote St-Luc, Moe Moscovitch, d'Outremont, tous deux avocats, Moe Levin, fabricant, «le Westmount, Reuben Gold, marchand, Jack Hirsch, Herman Deckel- (A.G.11819-59) R.Trottier Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May 1959, incorporating: Clovis Ares, industrialist, Rosaria Trottier.In usewife, wife separate as to property of the said Clovis Ares, and duly authorized by him for the purposes therein, both of the town of Mount Royal, and Marcel Bertrand, notary, of Venlun, for the following purposes: Deal in real estate, under the name «>f \"R.Trottier Ltée\", with a total capital stock of S2.000, divided into 200 shares of $10 each.The head office of the company wïll be at 8014 de l'Epée, Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May 1059.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11539-59) Sandra Land Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies*\"Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of March, 1959, incorporating: Abraham Feincr, Albert,Marcus, Isidore Reuben Prazoff, advocates, and Myrna Katz, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Sandra Land Development Corp.\".with a total capital stock of 8120,000, divided into 12,000 common shares of $1 each ami 108,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50806-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.12199-59) Seven Pillurs Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1959, incorporating: Melvin Salmon, of the Town of Côte St.Luc, Moe Moscovitch, of Outremont, both advocates, Moe Levin, manufacturer, of Westmount, Reuben Gold, merchant!, Jack Ilirsch, Herman Decklebaum, manufac- QUEHEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2677 baum, manufacturiers, et Irving Adessky, avocat, tous «piatre de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Seven Pillais Investment Corp.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 7,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, S.000 actions privilégiées, catégorie \"A\", «l'une valeur au pair de SI chacune et 3,500 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf avril 1059.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50S66 P.FRENETTE.(P.O.11S69-59) Stafford Development Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente-et-un mars 1959, constituant en corporation: Albert Marcus, Abraham Peiner et Isidore Reuben Prazoff, tous avocats, de Montréal, poulies objets suivants : Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et améliorations, sous le nom de \"Stafford Development Ltd.\".avec un capital total de $40.000, divisé en 5.000 actions ordinaires de $1 chacune et 35.000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente-et-un mars 1-059.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.turers, and Irvin Adessky, advocate, all four of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Seven Pillars Investment Corp.\", with a total capital stock of 850.000, divided into 7,000 common shares of a par value of 81 each.8,000 Classe \"A\" preferred shares of a par value of 81 each and 3,500 Class \"P»\" preferred shares of a par value of S10 each.The liead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth -lav of April, 1959.P.FRENETTE, \">08G0-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11869-59) Stafford Development Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March.1959.incorporating: Albert Marcus, Abraham Peiner and Isidore Reuben Prazoff, all advocates, of Montreal, for the following puposes: To carry on the business of a real estate and improvement company, under the name of \"Stafford Development Ltd.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 5,000 common shares of $1 each and 35.000 preferred shares of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11217-59) St.Clair Products & Equipment Ltd.Avis est donné «m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la pro\\1ru'e de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959.constituant en corporation: Êmé Lacroix, avocat et conseil en loi de la Reine, de Ville Mont-Royal, Armand Poupart, fils, avocat, et Monique Duquette, sténographe, célibataire, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Gérer et exercer le commerce «le constructeurs et entrepreneurs et faire le commerce «le toutes fournitures employées dans la construction, sous le nom de \"St.Clair Products & Equipment Lt«L\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1.000 actions onlinaires de 810 chacune et 900 actions privilégiées «le 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.12510-59) Suburban Land Sale Corp.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959.constituant en corpo- (A.G.11217-59) St.Clair Products & E«]iiipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day «>f April.1959.incorporating: Emé Lacroix, lawyer and Queen's Counsel, of the Town of Mount Royal, Armand Poupart.Jr., lawyer, and Monique Duquette, stenographer, single, both of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders ami contractors and to f 8100.000.divided into 1.000 common shares «>f 810 each ami 900 preferred shares of 8100 each.The hea«l office of the company will be at Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thin! day of April, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12510-59) Suburban Land Sale Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April.1959.incorporating: Bernard 2678 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec.27 juin 1959, Tome 91, N° 26 ration: Bernard Dorais, avocat, de Ste-Thérèse.Michel Côté, avocat, et Marie-Claire Lajoie Côté, ménagère, épouse séparée de biens dudit Michel Côté, tous deux de Roscmère, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Suburban Land Sale Corp.\", avec un capital total de 840,000.divisé en 100 actions communes de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15, rue de l'Eglise.Saintc-Thérèsc-de-Blainville, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.508GG-O P.FRENETTE.(P.G.11024-59) Taller Insurance Agency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1959, constituant en corporation: Michael Garber, conseil en loi de la Reine, Harry Yohalem Garber, tous deux de Westmount, et Jacob Harold Blumcnstcin, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Sujet aux dispositions de là Loi de l'Assurance de Québec (S.R.Q.1941, c.229) exercer, dans toutes ses spécialités, le commerce de courtiers d'assurances, sous le nom de \"Tafler Insurance Agency Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $5 chacune et 0,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.Dorais, advocate, of Ste-Thérèse.Michel Côté, advocate, and Marie-Claire Lajoie Côté, housewife, wife separate as to property of the said Michel Côté, both of Roscmère.for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate, under the name of \"Suburban band Sale Corp.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 100 common shares of S100 each, and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 15 Church Street.Sainte-Thérèse-dc-Blainville, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of April.1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11624-59) Taller Insurance Agency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1959, incorporating: Michael Garber, Queen's Counsel.Harry* Yohalem Garber.both of Westmount.and Jacob Harold Blumenstein, of Montreal, all advocates, for the following purposes: Subject to the provisions of the Quebec Insurance Act (R.S.Q.1941, c.229), to carry on in all its branches the business of insurance brokers, under the name of \"Tafler Insurance Agency Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 common shares of $5 each and 6.000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.12396-59) The Family Welfare Association of Montreal Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation sans capital-actions.\"The Family Welfare Association of Montreal\" une corporation antérieurement constituée en corporation en vertu de l'article 3007 des Statuts Révisés de 1888, tel que remplacé par le Statut Victoria 02, chapitre 32.le tout par Ordre en Conseil N° 42, daté du 23 janvier 1900, sous le nom de \"Montreal Charity Organization Society\" or Office Central de la Charité de Montréal, dont le nom original a été changé en celui de \"The Family Welfare Association of Montreal\", par Ordre-en-Conseil en date du 21 mars 1921.conformément aux dispositions de l'article 6922 des Statuts refondus de 1909, et avec les objets pour lesquels, la corporation a été constituée à son origine, les objets de la nouvelle corporation sont les suivants: Conserver et développer la vie de famille comme le fondement de la société humaine; assister les familles et les individus, développer et utiliser les capacités de chacun, examiner les problèmes personnels et sociaux en les soumettant à un service de conseillers professionnellement autorisés; donner une assistance pécu- (A.G.12390-59) The Family Welfare Association of Montreal Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Li utenant-Governor of the Province of Quel) c.bearing date the first day of May, 1959.to constitute as a corporation without share capital \"Tie Family Association of Montreal\", a corporation previously incorporated under Article 3097 of the Revised Statutes of 1888.as replaced by the Statute 02 Victoria, chapter 32.the whole by Order-in-Council No.42 dated January 23, 1900, under the name of \"Montreal Charity Organization Society\" or Office Central de la Charité de Montréal, which original name was changed to that of the \"Family Welfare Association of Montreal\", by Order-in-Council dated March 21, 1921 under the provisions of Article 6922 of the Revised Statutes of 1909, and that the purposes of the new corporation are.besides those for which it was originally constituted, the-following: To conserve and develop family life as the foundation of human society; to assist families and individuals to develop and make use of their own capacities to meet personal and social problems through the provision of a counselling service by a professionally trained staff; to render financial assistance where necessary; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec .lune 27tn, 1969, Vol.91.No.26 2679 maire en cas de nécessité, stimuler l'attention du public en vue d'améliorer les conditions sociales.Ix* nom de la nouvelle corporation est et demeure \"The Family Welfare Association of Montreal\".Ix' siège social de la nouvelle corporation sera situé en la cité «le Montréal.Le montant auquel est limitée la valeur «le la propriété immobilière «pic la nouvelle corpora tion peut p«>ssé«ler est $1,000,000.Daté «lu bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.0086(5 P.FREXF/1TE.(P.C.12785-60) Tyrone Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné «ni'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date «lu douze mai 1959, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant.David Henry Holland, avocat, tous deux «le St-Lambert, Alexander Gordon Yeoman, John Lawrence Mc('rory,tous deux commis en lx>i, Clifford George Meek, teneur «le livres, tous trois de Montréal, Charles Eric Humphrey, teneur de livres, de Verdun, et James Harold Stafford, commis, de Station Reloeil, pour les objets suivants: Faire «les recherches et des explorations pour découvrir «les mines et minerais, et les négocier, sous le nom de \"Tyrone Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de 8100,000, divisé en 100,000 actions d'une valeur au pair de 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune respon-babilité au delà du montant «lu prix qu'ils auront payé ou ceonvenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le douze mai 1959.L'Assistant-proeureur général supplé'ant, 50866 P.FRENETTE.and tro|x*rtv which the new corporation may hold IS to be limited is $1,000.000.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of May.1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12785-59) Tyrone Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Minig Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May.1959.incorporating: Ernest William Mockridge, manager, David Henry Holland, advocate, both of St.Lambert, Alexander Gordon Yeoman, John Lawrence Mc-Crory, both law clerks, Cliffor«l George Meek, bookkeeper, all three of Montreal, Charles Eric Humphrey, bookkeeper, of Verdun, and James Harold Stafford, elerk, of Heloeil Station, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals ami deal with the same, under the name of \"Tyrone Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 8100,000, divided into 100.000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company f«>r its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth dav of May, 1959.P.FRENETTE, 508GG-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14595-58) Warren-Gold Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ixti des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: Irving L.Adessky.Moses Moscovitch et Melvin Salmon, tous avocats, «le Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre la transformation, fabrication, construction, érection et entretient de machinerie et équipement de plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, arrosage et réfrigération, sous le nom «le \"Warren-Gold Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 clittcune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district jmliciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(A.G.14595-58) Warren-Gold Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1959, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch and Melvin Salmon, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To engage in the manufacture, fabrication, construction, erection and maintenance of plumbing, heating, ventilating, air-conditioning, sprinkler ami refrigeration machinery and equipment, under the name of \"Warren-Gold Co.Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 commom shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-sixth day of March, 1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General. 2680 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 19Ô9, Tome 91, .V° £6 (P.G.11406-50) Wclton International Corporation Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéhec des lettres patentes, en date du premier avril 1959, constituant en corporation: Paul Gostony, gérant de personnel, de St-' Laurent, Arthur Wclton, consultant industriel, et Betty Edmond, secrétaire, épouse légalement séparée de biens de Barry Edmond, mg« nieur de ventes, en vertu des Lois de l'Angleterre, et dûment autorisée par ce dernier, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme consultants dans les domaines de l'industrie et du commerce et comme consultants de personnels, sous le nom de \"Wclton International Corporation\", aved un capital total de $50,000, divise en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50800 P.FRENETTE.(P.G.11992-59) Western Tire & Auto Supply (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première pzrtie de la lx>i des compagnies de Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1959, constituant en corporation: IxSo Davignon, comptable, de Laval-des-Rapides, Reginald I).Tormey et Glande Guérin, avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'aucune ou toutes les spécialités de quincailliers, et acheter, vendre, fabriquer, traiter, distribuer, importer et exporter tous genres d'articles de quincailleries, appareils et accessoires électriques, pièces d'automobiles et accessoires et fournir tous les services se rapportant à un tel commerce, sous le nom de \"Western Tire & Auto Supply (Quebec) Limited\", avec un capital total de 850.000, divisé en 10,000 actions de 85 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866 P.FRENETTE.(P.G.12303-59) Yvon Dupuis Musique Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu vingt avril 1959, constituant en corporation: Yvon Dupuis, marchand,.de St-Jean, Françoise Savard.secrétaire, célibataire, majeure, et Guy Rouleau, avocat, tous «Jeux «le Montréal, pou.-les objets suivants: Commerce d'appareils «le radio, «le télévision, appareils d'enregistrement, phonographes, accessoires électriques, instruments de musique et autres marchandises semblables, sous le nom de \"Yvon Dupuis Musique Ltée'.', avec un capital total «le $40,000.«livisé en 2.000 actions communes «le $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.(A.G.11405-50) Wclton Internationa] Corporation Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of QucIh'c, bearing date the first f Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of April.1959.P.FRENETTE, 50800-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11992-59; Western Tire & Auto Supply (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-third day of April, 1959.incorporating: Léo Davignon, accountant, of Laval-des-Rapides, Reginald D.Tormey and Claude Guérin, layers, of Montreal, for the following purposes: To carry on any or all lines of hardware merchants, and to buy.sell, manufacture, process, distribute, import and export all types of hardware articles, electrical appliances and accessories, automobile parts and accessories and to provide all the usual services incidental to such business, under the name of \"Western Tire & Auto Supply (Quebec) Limited\", with a total capital stock of 850.000.divided into 10,000 shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April.1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12303-59) Yvon Dupuis Musique Ltée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: Yvon Dupuis.merchant, of St.Johns, Françoise Savard, secretary, spinster of full age of majority, and Guy Rouleau, advocate, both of Montreal, for the following purposes: Deal in radio and televisions sets, recording machines, phonographs, electrical accessories, musical instruments and other similar goods, under the name of \"Yvon Dupuis Musique Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each ami 200 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.S6 2681 Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'lberville.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.(P.G.12636-59) ' Yvon Giguère Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéhec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quéhec des lettres patentes, en date du cinq mai 1959, constituant en corporation: Yvon Giguère, entrepreneur, Eustache Giguère.journalier, et Rita Laplantc Giguère.ménagère, épouse commune en biens dudit Yvon Giguère.et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Magog, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Yvon Giguère Inc.\", avec un capital total de 8-10,000, divisé en -100 actions communes de 8100 cl lacune.Ix; siège social de la compagnie sera à Magog.district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.(P.G.11196-59) Zurich Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1959, constituant en corporation: Maynard B.(Jolt, avocat.Micheline Bertrand, et Anna Mikula, secrétaires, célibataires, tons de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de placements, sous le nom de \"Zurich Investment Corp.\", avec un capital total de 810.000, divisé en 1,000 actions ordinaires et 9,000 actions privilégiées, toutes d'une valeur au pair de Si chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant procureur général suppléant.50866 P.FRENETTE.Lettres patentes supplémentaires (P.G.12694-59) Alouette Canadian Soccer Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes suplé-mentaires, en date du quatre mai 1959.à la compagnie \"Sparta Football Club (Montreal) Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Quelle, par lettres patentes du 21 février 1958.changeant son nom en celui de \"Alouette Canadian Soccer Club Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le quatre mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.The head office of the company will be at Saint Johns, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twentith dav of April.1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney Genera).(A.G.12636-59) Yvon Giguère Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May.1959, incorporating: Yvon Giguère, contractor.Eustache Giguère, laborer, and Rita baillante Giguère, housewive, wife common as to property of the said Yvon Giguère.and duly authorized by him for these purposes, all of Magog, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Yvon Giguère Inc.\".with a total capital stock of 810.000.divided into -100 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Magog, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of May, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting'Deputy Attorney General.(A.G.11196-59) Zurich Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor ofAthe Province of Quebec, bearing date the first day of April, 1959.incorporating: Maynard B.Golt, advocat, Micheline Bertrand and Anna Mikula.secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of investment, under the name of \"Zurich Investment Corp.\", with a total capital stock of 810.000.divided into 1.000 common shares ami 9.001» preferred shares all of a par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50866-o Acting Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent (A.G.12(194-59) Alouette Canadian Soccer Club Ino.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fourth day of May.1959.to the company \"Sparta Football Club (Montreal) Inc.\".constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies'Act.by letters patent dated February 21, 1958.changing its name to that of \"Alouette Canadian Soccer Club Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of May.1959.P.FRENETTE.50866 Acting Deputy Attorney General. 2082 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tonte 91.N° 2J (P.C.14255-58) Association Sportive d'Ibervillé, Ine.Avis est donné qu'en vertu «les dispositions de la Ix)i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente avril 1959.à la corporation \"La Ligue de Balle Molle d'Ibervillé Incorporée\", constituée en vertu de la troisième partie de ladite loi, par lettres patentes du 18 septembre 1952.changeant son nom en celui de \"Association Sportive d'Ibervillé.Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50800-O P.FRENETTE.(A.G.14255-58) Association Sportive d'Ibervillé, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of April.1959.to the corporation \"La Ligue de Balle Molle d'Ibervillé Incorporée\", incorporated under Part III of the said act, by letters patent of September 18, 1952, changing its name into that of \"Association Sportive d'lberville, Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April.1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12589-59) Bijouterie Pierre Jewellery Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente avril 1959.à la compagnie \"Bijouterie Pierre Jewellery Company\"; 1° augmentant son capital de 840.000 à 880,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune; 2° convertissant ses 300 actions privilégiées de $100 chacune en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50806-O P.FRENETTE.(A.G.12589-59) Bijouterie Pierre Jewellery Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Aet.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated thirtieth day of April, 1959.to the company \"Bijouterie Pierre Jewellery Company\", 1.increasing its capital from the sum of $40.000 to 880,000, the additional share capital being divided into 400 common shares of $100 each; 2.converting its 300 preferred shares of 8100 each into 300 common shares of S.100 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April.1959.P.FRENETTE.50800 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11499-59) Cable T.V.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires; en date du quatorze mai 1959.à la compagnie \"Suburban Teleservice Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la I/oi des compagnies de Québec, par lettres patentes du G octobre 195G, changeant son nom en celui de \"Cable T.V.Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-O P.FRENETTE.(P.G.12169-59) Caiiado Clima Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I>oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze avril 1959.à la compagnie \"Canado Clima Inc.\".augmentant son capital de $40.000 à $115.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 750 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.508G6-O P.FRENETTE.(A.G.11499-59) Cable T.V.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May fourteenth.1959.to the company \"Suburban Teleservice Inc.\".incorporated under the said said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated October 6, 1956, changing its name into that of \"('able T.V.Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1959.P.FRENETTE, 508GG Acting Deputy Attorney General.' (A.G.12109-59) Canado Clima Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of April.1959.to the company \"Canado Clima Inc.\", increasing its capital stock from $40.000 to $115.000.the additional capital stock being divided into 750 common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 508G6 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 19Ô9, Vol.91, No.26 2683 (P.G.12583-59) Carbcc Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze mai 1959, à la compagnie \"Alta Mines Limited\" (No Persona] Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes du 6 juin 1945.changeant son nom en celui de \"Carbee Mines Limited\" (No Personal Liaiblity).Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.12173-59) Carrière Gouin Limitée Gouin Quarry Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept avril 1959, à la compagnie \"Carrière Gouin Limitée \u2014 Gouin Quarry Limited\".1° subdivisant ses 50 actions ordinaires de 8100 chacune en 500 actions ordinaires de 810 chacune; 2° augmentant sou capital de $5,000 à $55,000.le capital-actions additionnel étant divisé en 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508G6-o P.FRENETTE.(P.G.12408-59) Cog Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois avril 1959, à la compagnie \"Cog Co.\", augmentant son capital de $10,000 à $150.000.le capital-actons additionnel étant divisé en 14,000 actions privilégiées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.12163-39) Continental Store (Campbellton) Ltd.Magasin Continental (Campbellton) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix avril 1959, à la compagnie \"Continental Store (Campbellton) Ltd.\u2014 Magasin Continental (Campbellton) Ltée\", augmentant son capital de $20,000 à $40,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.(A.G.12583-59) Carbec Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Act and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twelfth.1959.to the company \"Alta Mines Limited\" (No Personal Liability), incorporated under the said Quebec Mining Act, by letters patent of June 6, 1945, changing its name into that of \"Carbec Mines Limited\" (No Personal Liability).Dated at the ofliee of the Attorney General, this twelfth day of May, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12173-59) Carrière Gouin Limitée Gouin Quarry Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Comapnies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the seventeenth day of April 1959, to the company \"Carrière Gouin Limitée \u2014 Gouin Quarry Limited\", 1° subdividing its 50 common shares of $100 each into 500 common shares of $10 each; 2° increasing its capital from the sum of $5,000 to $55.000, the additional share capital being divided into 5.000 preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April.1959.P.FRENETTE, 50860 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12408-59) Cog Co.'Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated April twenty-third, 1959.to the company \"Cog Co.\", increasing its capital stock from $10.000 to $150,000, the additional capital stock being divided into 14,000 preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of April.1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12163-59) Continental Store (Campbellton) Ltd.Magasin Continental (Campbellton) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplemantary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of April 1959.to the company \"Continental Store (Campbellton) Ltd.\u2014Magasin Continental (Campbellton) Ltée\", increasing its capital from the sum of $20.000 to $40,000, the additional share capital being divided into 200 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April.1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General. 2684 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome.91.N° 26 (P.G.10772-59) Consolidated Plywood Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur tic la province de Quéhec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze février 1959.à la compagnie \"Consolidated Plvwood Corporation\".1° réduisant son capital de $60,000 à S 10.000, le capital-actions annulé étant divisé en 800 actions ordinaires de 850 chacune; 2° augmentant son capital ainsi réduit de 810.000 à 8110.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 1.000 actions classe \"A\" de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le douze février 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508GG-O P.FRENETTE.(P.G.11747-58) Pi ran i Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu vingt-huit avril 1959.à la compagnie \"Eiram Limitée\".1° réduisant son capital de 850.000 à 810.000, le capital-actions annulé à tant «livisé en 810 actions privilégiées de 8100 chacune et en 90 actions ordinaires «le S100 chacune; 2° subdivisant ses 90 actions privilégiées «le 8100 chacune restantes en 900 actions privilégiées de 810 chacune; 3° subdivisant ses 10 actions ordinaires de 8100 chacune restantes en 100 actions ordinaires «le 810 chacune.Daté du bureau «lu Piocureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508G6-O P.FRENETTE.(P.G.12610-59) Fairlanc Development Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un mai 1959, à la compagnie \"Supertcst Construction Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes du 3 juin 1958, changeant son nom en celui de \"Fairlanc Development Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.508G6-O P.FRENETTE.(P.G.12084-59) Gauthier .Meubles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu vingt mai 1959, à la compagnie \"Ernest Régin & Fils Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, par lettres patentes «lu 8 août 1957, changeant son nom en celui de \"Gauthier Meubles Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508G6-O P.FRENETTE.(A.G.10772-59) Consolidated Plvwood Corporation Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twelfth rated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent date«l June 3, 1958, changing its name into that of \"Fairlanc Development Inc.\".Dated at the office of the Attoreny General, this twentv-first dav of May, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12084-50) Gauthier Meubles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, dated May twentieth, 1959, to the company \"Ernest Begin & Fils Limitée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated August 8.1957, changing its name into that of \"Gauthier Meubles Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General. QUEIŒC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, loi.91.So.SO 2685 (P.G.12311-50) Gilroy Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Iah des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze mai 1950.à la compagnie \"Roy & Rouillard Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 20 avril 1950.changeant son nom en celui de \"Gilroy Construction Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.(A.G.12311-59) Gilroy Construction Limited Notice is hereby given that under Fart I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eleventh day of May.1959.to the company \"Roy & Rouillard Limited\", Constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated April 20.1950.changing its name to that of \"Gilroy Construction Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of May, 1959.P.FRENETTE, 50X66 Acting Deputy Attorney General.(P.G.1217-1-59) Inter-Cité Transport Limitée Inter-City Transport Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires,-en date du dix-sept avril 1959.à la compagnie \"Inter-Cité Transport Limitée \u2014 Inter-City Transport Limited\".1° augmentant son capital de 850,000 à 8150.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 10.000 actions privilégiées de 810 chacune; 2° subdivisant ses 500 actions ordinaires de 8100 chacune en 5.000 actions ordinaires de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.(P.G.12410-59) Lachine .Super Market Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un avril 1959.à la compagnie \"Lachine Super Market Inc.\".modifiant les dispositions de ses lettres patentes de constitution en corporation.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un avril 1959.1/Assistant-procureur général suppléant.50806-o P.FRENETTE.(A.G.12174-59) Inter-Cité Transport Limitée Inter-City Transport Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the seventeenth day of April.1959.to the company \"Inter-Cité Transport Limitée \u2014 Inter-City Transport Limited\".1.increasing its capital from the sum of 850.000 to 8150,000.the additional share capital being divided into 10.000 preferred shares of S10 each; 2.subdividing its 500 common shares of 8100 each into 5.000 common shares of S10 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April.1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12410-59) Lachinc Super Market Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-first day of April 1959, to the company \"Lachine Super Market Inc.\", modifying the provisions of its incorporation letters patent.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of April.1959.P.FRENETTE, 50X00 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12245-59) I aitel Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze avril 1959, à la compagnie \"Magno Machinery Co.Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Ix>i des compagnies de Quél>ec, par lettres patentes du X novembre 1957.1°) étendant ses pouvoirs; 2r) changeant son nom en celui de \"Laird Realty Corp.\".Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50X66-o P.FRENETTK.(A.G.12245-59) Laird Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of April.1959, to the company \"Magno Machinery Co.Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of November X, 1957, 1) extending its powers; 2.) changing its name into that of \"Laird Realty Corp.\".Dated at the office of the Attorney General,, this fifteenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 50X00 Acting Deputy Attorney General. 2686 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 96 (P.G.12686-59) L.D.& H.Schreiber Ltd.Avis est ilonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit avril 1959, à la compagnie \"Henri Bourassa Blvd.Shopping Centre Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 29 janvier 1959, changeant son nom en celui de \"L.D.& H.Schreiber Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.(1\\(;.12447-59) LeChasseur Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de» la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit avril 1959.à la compagnie \"LeChasseur Inc.\", augmentant son capital de 820.000 à 828.300.le capital-actions additionnel étant divisé en 83 actions privilégiées de SUM) chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.12102-59) Lefebvre Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze avril 1959, a la compagnie \"Lefebvre Automobiles Ltée\".augmentant son capital de 840.000 à $150.000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 950 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.(A.G.12686-59) L.D.& IL Schreiber Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-eighth day of April 1959, to the company \"Henri Bourassa Blvd.Shopping Centre Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated January 29, 1959, changing its name to that of \"L.D.& H.Schreiber Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of April 1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(A.G.124-17-59) LeChasseur Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the.Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-eight h day of April, 1959, to the company \"LeChasseur Inc.\", increasing its capital from the sum of 820.000 to $28.300.the additional share capital being divided into 83 preferred shares of $100 each.\u2022 Dated at the office of the Attorney-General, this twenty-eighth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12102-59) Lefebvre Automobiles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of April.1959, to the company \"Lefebvre Automobiles Ltée\", increasing its capital from the sum of $40,000 to $150.000, the additional share capital being divided into 1.500 common shares of $10 each ami 950 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of April.1959.P.FRENETTE.50866 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12705-59) Les Entreprises de l'Est Ltée Eastern Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec dès lettres patentes supplémentaires, en date du onze mai 1959.à la compagnie \"Les Entreprises de l'Est Ltée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 24 janvier 1947.1° changeant son nom en celui «le \"Les Entreprises de l'Est Ltée \u2014 Eastern Enterprises Ltd.\"; 2° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 55806-o P.FRENETTE.(A.G.1,2705-59) Les Entreprises de l'Est Ltée Eastern Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May eleventh, 1959, to the company \"Les Entreprises de l'Est Ltée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act.by letters patent of January 24, 1947, 1.changing its name into that of \"Les Entreprises de l'Est Ltée \u2014 Eastern Enterprises Ltd.\"; 2.extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June >7th, 19Ô9, Vol.91.So.>r, 2(587 (P.G.14091-58) Les Frères Brisson Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Quéhec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de (Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du onze mai 1959, à la compagnie \"Les Frères Brisson Fourreurs Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la I*oi des compagnies de Quéhec, par lettres patentes du 13 mai 1955, changeant son nom en celui de \"Les Frères Brisson Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant -procu reu r général suppléant! 508G(5-o P.FRENETTE.(P.G.12539-59) L'Hoir Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente avril 1959.à la compagnie \"L'Hoir Inc.\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.12140-59) Lirsh Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du sept avril 1959, à la compagnie \"St.Hul>ert Fourrures Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 21 avril 1958, 1° changeant son nom en celui de \"Lirsh Enterprises Inc.\"; 2° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-0 P.FRENETTE.(P.G.10350-59) Montroy Investment Company, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en da'e du six mai 1959.à la compagnie \"Montroy Investment Company.Limited\", réduisant son capital de Sl.500.000 à 81.332.800.le capital-actions annulé étant divisé en 1(57.200 actions privilégiées de 81 chacune.Daté «lu bureau du Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.508G6-o P.FRENETTE.(P.G.12370-59) Morisset Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes supplé- (A.G.14991-58) Les Frères Brisson Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, dated the eleventh day of May 1959, to the company \"Les Frères Brisson Fourreurs Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 13.1955, changing its name to that of \"Les Frères Brisson Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May 1959.P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12539-59) L'Hoir Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of April 1959.to the company \"L'Hoir Inc.\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of April 1959.P.FRENETTE, 5080(5 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12146-59) Lirsh Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Qucl>cc, dated April seventh.1959.to the company \"St.Hubert Fourrures Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quelle Companies' Act, by letters patent «>f April 21, 1958.I.changing its name into that of \"Lirsh Enterprises Inc.\"; 2.extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of April.1959.P.FRENETTE.50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10350-59) Montroy Investment Company, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters habent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, dated the sixth day of May 1959.to the company \"Montroy Investment Company, Limited\", decreasing its capital from the sum of 81.500.0(H) to $1.332.-800.the cancelled share capital being divided into 107.200 preferre«l shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of May 1959.P.FRENETTE.5080(5 Acting Deputy Attorney General.(AG.12370-59) Morisset Automobiles Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the 2688 GAZETTE GEE ICI ELLE DE QUEBEC.Québec 27 juin 7959, Tome 91.N° m mentaires, en date du vingt-cinq avril 1959, à la compagnie \"Morisset Automobiles Inc.\", 1°) augmentant son capital de $200.01)0 à $350.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 15.000 actions privilégiées de 810 chacune: 2° étaudant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq avril 1059.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508G0-o P.PRENETTE.(P.G.12371-50) Obic's .Meat Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un avril 1959, à la compagnie \"Obic's Meat Inc.\",étant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.PRENETTE.(P.G.12000-59) Paul Guimond Limited Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres pateides supplémentaires, en date du six mai 1959, à la compagnie \"Paul Guimond Limited\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.PRENETTE.(P.G.14898-58) Placements St-Régis Inc.St-Regis Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur tie la province tie Quéhec des lettres patentes supplémentaires, en date du neuf mars 1959, à la compagnie \"Service d'Hôtellerie St-Régis Inc.\u2014 St.Regis Hotel Service Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 27 novembre 1945, 1°) changeant son nom en celui, tie \"Placements St-Régis Inc.\u2014 St-Regis Investments Inc.\"; 2°) étendant ses pouvoirs; 3°) modifiant les dispositions se rattachant aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mars 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 508G6-o P.PRENETTE.(P.G.12007-59) Portage Island (Chibougamau) Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu îles dispositions tie la Loi ties compagnies minières tie Québec et tie la première partie tie la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur tie la province tie Québec ties lettres patentes supplémentaires, en tlate du six mai 1959.à la compagnie \"Portage Island (Chibou- twcnty-fifth.day of April.1959, to the company \"Morisset Automobiles Inc.\", I.increasing its capital stock from 8200,000 to $350.000, the additional capital stock being divided into 15.000 preferred shares of $10 each.2.extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of April, 1959.' P.PRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12371-59) Obic's Meal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated April twenty-first.1959.to the company \"Obic's Meat Inc.\".extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of April.1959.\" P.FRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12606-59) Paul Guimond Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, tlated May sixth.1959, to the company \"Paul Guimond Limited\", extending its powers'.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14898-58) Placements St-Régis Inc.St-Regis Investments Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, tinted the ninthc day of March 1959.to the company \"Service d'Hôtellerie St-Régis Inc.\u2014 St.Regis Hotel Service Inc.\".constituetl as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act.by letters Patent dated November 27, 1945, 1.) changing its name to that of \"Placements St-Régis Inc.- St.Regis Investments Inc.\"; 2.) extending its powers'; 3.) modifying the provisions attaching to the preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of March.1959.P.FRENETTE, 508(H) Acting Deputy Attorney General.(A.G.12007-59) Portage Island (Cliilmugamaii) Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act ami Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated sixth day of May 1959, to the company \"Portage Island (Chibougamau) Mines Limited\" QUEHEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 19Ô9, Vol.91, No.26 2689 ganiuu) Mines Limited\" (No Personal Liability), augmentant son capital de $5,000,000 à $6,000,-000.le capital-actions additionnel étant divisé en 1.000,000 actions ordinaires de SI chacune.Daté du bureau de Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.PRENETTE.(P.G.12449-59) Quebec.Smelting & Refining Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit avril 1959, à la compagnie \"Quebec Smelting & Refining Limited\" (No Personal Liability), augmentant son capital de S5.000.000 à 86,000,-000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000,000 actions ordinaires de SI chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 508G6-o P.FRENETTE.(P.G.10890-59) Segal Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf avril 1959, à la compagnie \"Segal Limited\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50S66-o P.FRENETTE.(P.G.12148-59) Sicard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze avril 1959, à la compagnie \"Sicard Inc.\", 1° augmentant son capital de 436,000 actions ordinaires sans valeur au pair à 052,000 actions ordinaires sans valeur au pair; 2° fixant le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations à non moins de $3,200,000.v Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.50806-O P.FRENETTE.(P.G.12409-59) The Dominion News Bureau Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux avril 1959, à la compagnie \"The Dominion News Bureau Limited\", 1° réduisant son capital de $85,000 à $20,300, le capital-actions annulé étant divisé en 5,870 actions privilégiées de $10 chacune; (No Personal Liability), increasing its capita' from the sum of $5,000.000 to $6,000,000, the additional share capital being divided into 1.000.000 common shares of 81 each.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1959.P.FRENETTE.50866 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12449-59) Quebec Smelting & Refining Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-eighth day of April, 1959.to the company \"Quebec Smelting & Refining Limited\" (No Personal Liability), increasing its capital stock from 85,000.000 'to 80,000.000, the additional capital shares being divided into 1.000,000 common shares of 81 each.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-cighth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50860 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10890-59) Segal Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated April twenty-ninth, 1959, to the company \"Segal Limited\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12148-59) Sicard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of April, 1959, to the company \"Sicard Inc.\", 1.increasing its capital from 430.000 common shares without par value to 052,000 common shares without par value; 2.fixing the amount with which the said company shall continue its operations at not less than S3,2G0,000.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12409-59) The Dominion News Bureau Limited Notice is hereby given that under Paît I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated twenty-second day of April 1959, to the company \"The Dominion News Bureau Limited\", 1.decreasing its capital from the sum of $85,000 to $26,300, the cancelled share capital being divided into 5,870 preferred shares of 810 each; 2090 GAZETTE DEEICI ELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 2° augmentant son capital ainsi réduit de $26,300 à §120,300.le capital-actions additionnel étant divisé en 10.000 actions privilégiées classe \"B\" de S10 chacune; 3° changeant les 030 actions privilégiées antérieurement autorisées de $10 chacune en 030 actions privilégiées classe \"A\" de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant.60866-O P.PRENETTE.(P.G.12305-59) Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des'lettres patentes supplémentaires, en date du huit mai 1959.à la compagnie \"Triumph Continental Products Ltd.\", constituée en corporation en certu de ladite première partie de la I>oi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 19 mai 1945, changeant son nom en celui de \"Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50800-O P.FRENETTE.(P.G.11386-59) ( - Universal Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur ilc la province de Québec dés lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit avril 1959, à la compagnie \"Universal Enterprises Limited\", réduisant son capital de 86,000 à $1,200, le capital-actions annulé étant divisé en 4,800 actions ordinaires de 81 chacune; 2° augmentant son capital ainsi réduit de $1,200 à $475,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 23,800 actions ordinaires de SI chacune et en 45,000 actions privilégiées de $10 chacune; 3° modifiant ses pouvoirs tel que prévu par la résolution dûment adoptée à cette fin.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-O P.FRENETTE.(P.G.12413-59) Variety Investors Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois avril 1959, à la compagnie \"Variety Investors Incorporated\", réduisant son capital de $75,000 à $6,500, le capital-actions annulé étant divisé en 335 actions ordinaires de $100 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau de Procureur général, le vingt-trois avril 1959.L'Assistant-proeureur général suppléant, 50866-o P.FRENETTE.(P.G.11631-59) Volkswagen Sales & Service Ltd.2.increasing its capital thus decreased from $26,300 to 8120,300, the additional share capital being divided into 10,000 preferred shares class \"B\" of $10 each; 3.changing the 030 preferred shares previously authorized of $10 each into 030 preferred shares class \"A\" of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of April 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12305-59) Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eighth day of May 1959, to the company \"Triumph Continental Products Ltd.\".constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act.by letters patent dated May 19.1945, changing its name to that of '\"Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.\" Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of May 1959.P.FRENETTE, 50860 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11380-59) Universal Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-eighth day of April, 1959 to the company \"Universal Enterprises Limited\", 1.reducing its capital stock from $0,000 to $1,200, the capital stock cancelled being divided into 4,800 common shares of $1 each: 2.increasing the capital stock thus reduced from $1,200 to $475,000, the additional capital stock being divided into 23,800 common shares of $1 each and into 45,000 preferred shares of $10 each; 3.amending its powers as provided for by the resolution duly adopted for this purpose.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1959.P.FRENETTE, 50806 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12413-59) Variety Investors Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-third day of April, 1959, to the company \"Variety Investors Incorporated\", reducing its capital stock from $75,000 to $6,500, the cancelled capital stock being divided into 335 common shares of $100 each and into 350 preferred shares, of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this third day of April, 1959.P.FRENETTE, 50800 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11631-59) Volkswagen Sales & Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary QUEBEC OFFICIA L GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No, 26 2691 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province tic Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit avril 1959, à la compagnie \"Volkswagen Sales & Service Ltd.\", modifiant les dispositions de ses lettres patentes antérieures en ce qui concerne les conditions attachées à ses actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1950.L'Assistant-proeureur général suppléant.50866-o P.FRENETTE.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-eighth day of April.1959, to the company \"Volkswagen Sales & Service Ltd.\", amending the provisions of its previous letters patent in that which concerns the conditions attached to its preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of April.1059.\" P.PRENETTE, 50866 Acting Deputy Attorney General.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAM PRE DU CONSEIL EXECUTIF Numéro 614.Section A\" Quéhec.le 18 juin 1959.Présent : Ix' Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au décret relatif aux employés de garages dans l'Ile de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941.chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil, une modification au décret numéro 184 du 8 février 1950 et amendements, relatif aux employés de garages dans l'Ile de Montréal; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 1(5 mai 1959; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ou donné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que ledit décret, numéro 184, soit modifié comme suit : Le paragraphe \"//' de l'article XI est remplacé par le suivant: \"b) Aucun apprenti ne peut être accepté s'il n'a pas seize (16) ans révolus.L'apprenti doit fournir un cerificat d'études de septième année du cours primaire ou l'équivalent.\" L.DÉSILETS, 50870-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 014 Section \"B\" Québec, le 18 juin 1959.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Joliette.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 103 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 701 du 13 juillet 1955 et amen- Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCTL CHAMBER Number 614 Part \"A\" Quebec, June 18, 1959.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment of the decree relating to the garage employees in the Island of Montreal.^ Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the decree number 184 of February 8.1950 and amendments, relating to the garage employees in the Island of Montreal; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of Mav 16, 1959; Whereas no objection lias been made against the approval of the proposed amendment; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Prime Minister: That the said decree, number 184.be amended as follows: Paragraphe \"//' of article XI is replaced by the following: \"&) No apprentice can be accepted if he is under sixteen (16) years of age.The apprentice shall produce a certificate of study of the seventh year of the Primary Course or the equivalent thereof.\" L.DÉSILETS, 50876-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 614 Part \"B\" Quebec.June 18, 1959.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Joliette.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 761 of July 13, 1955 and amendments, 2692' GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 dements, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Joliette, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu quk ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 16 mai 1959; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées: Ii, est ou don né.en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre: Que ledit décret, numéro 761, soit modifié comme suit : 1° Les paragraphes \"o\", \"b\" et \"h\" de l'article V sont remplacés par les suivants: \"V.7'a/u- de salaires minima: a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés: Taux horaires A compter du 1er Métiers.avril 1960 Brasseur de mortier.$ 1.40 S 1.40 Brasseur de célanile.1.40 1.40 Briqueteur-maçon.1.80 1.80 Calfat.1.40 1.40 Charpentier-menuisier.1.90 2.00 ( 'haull'cur (construction).1.50 1.50 Chaudronnier.1.80 1.80 Conducteur de monte-charge .1.35 1.35 Conducteur de tracteur.1.55 1 .55 Conducteur de rouleau compresseur (vapeur ou essence) 1.50 1.50 ( 'onducteur de niveleuse ou de lwlier mécanique.1.50 1.50 Chauffeur de bouilloire (4ème classe).1.38 1.38 Électricien (compagnon).1.95 2.05 Ferblantier (boutique ou chantier).1.90 2.00 Compagnon junior.1.55 1.65 Finisseur de (Minent.1.75 1.75 Finisseur de plancher en mastic 1.75 1.75 Foreur et poudrier.1.75 1.75 Forgeron sur chantier.1.75 1.75 Gratteur, polisseur et sableur de plancher.^.1.80 1.80 (Jréeur (à la main ou à la machine).1.80 1.80 Journalier.1.40 1.50 Lettreur pour fins commerciales.1.90 1.90 Limeur de scie.1.90 2.00 Manoeuvre.1.40 1.50 Machiniste.1.80 1.80 Mécanicien en isolation de tuyauterie.1.80 1.80 Mécanicien en tuyauterie.1.90 2.00 Mécanicien en tuyauterie (compagnon junior).1.55 1.65 Mécanicien de machine fixe ou portative.1.40 1.40 Peintre-doreur.1.80 1.80 Paysagiste.1.30 1.30 Pilonneur.lisseur et épandeur d'asphalte.1.30 1.30 Peintre.1.65 1.65 Plâtrier.1.80 1.80 Porteur d'eau.1.30 1.30 Poseur de lattes en métal ou de composition.1.65 1.65 Poseur de lattes en bois.1.55 1.55 Poseur d'acier d'armature.1.90 2.00 Poseur de liège (isolation).1.80 l .80 Poseur de couvre-plancher.1.80 1.80 relating to the construction industry and trades in the region of Joliette.have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree: whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of May 10.1959; whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Prime Minister: That the said decree, number 7(51, be amended as follows: 1.Subsections \"a\".\"6\" and \"h\" of article V are replaced by the following: \"V.Minimum xcage rates: a) The minimum wage rates shall be as follows: Hourly rates From April Trades: 1st, 1960 Mortar mixer.81.40 81.10 Celanite mixer.1.40 1.40 Bricklayer \u2014 mason.1.80 1.80 Caulker.1.40 1.40 Carpenter, joiner .1 .90 2.00 Fireman (construction).1.50 1.50 Boilermaker.1.80 1.80 Freight elevator operator .1.35 1.35 Tractor operator.1.55 1.55 Roller operator (steam or gasoline).1.50 1.50 Grader or bulldozer operator 1.50 1.50 Boiler fireman required to hold 4th class certificate .1.38 1 .38 Electrician (journeyman) .1.95 2.05 Tinsmith, shop or field.} .90 2.00 Junior journeyman.1.55 1.05 Cement finisher.1.75 1.75 Mastic floor finisher.1.75 1.75 Drill operator and blaster.1.75 1 .75 Blacksmith on the job.I .75 1.75 Floor scraper, polisher and sander.180 1.80 Rigger (hand or machine).1.80 1.80 Common worker.1.40 1.50 Commercial letterer.1.90 1.90 Saw filer.190 2.00 Labourer.1-40 1.50 Millwright.1.80 1.80 Pipe insulation mechanic.1.80 1.80 Pipe mechanic.1 90 2.00 Pipe mechanic (junior journeyman).1.55 1.05 Engineman (stationary or portable engine).140 1.40 Painter, gilder.180 1.80 Landscape worker.1-30 1.30 Asphalt ramming, smoothing and spreading.1.30 1.30 Painter.165 1.65 Plasterer.180 1.80 Water carrier.1.30 130 Lather, metal or composition .1.65 1.65 Lather, wood.1.55 1.55 Reinforcing steel erector.1.90 2.00 Insulation cork setter.180 1.80 Oilcloth layer.180 1.80 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.June 27th.1959, Vol.91.No.26 2693 Taux horaires A com/iter du 1er avril I960 Poseur de plancher en mastic.$1X0 $1.80 Poseur de tuile, asphalte et terrazzo.1.80 1.80 Poseur de marbre.I .SO 1.80 Préposé aux malaxeurs à vapeur ou gazoline.1.50 I 50 Préposé aux sonnettes (bois ou béton).1.45 1.45 Préposé aux malaxeurs à l'électricité OU petit malaxeur.I .40 1 .40 Préposé aux bouilloires (travail de plancher seulement) .1.40 1.40 Préposé aux machines à polir le terraz/.o.1.50 1.50 Préposé aux grues.1.50 1.50 Préposé aux pelles mécaniques 1.85 1.85 Préposé à la canalisation, mu-teur et soudeur.1.30 1.30 Préposé aux compresseurs.1.50 ] .50 Râtisseur d'asphalte.1.30 1.30 Soudeur en tuyauterie (acétylène ou électricité).1.90 2.00 Surveillant employé également comme chauffeur et devant posséder un certificat de 4ème classe.1.38 1.38 Travailleur en fer ornemental 1.30 1.30 Gardien sur chantier (à la semaine).55.00 \u202260.00 /;) Salaires minima des apprentis: Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux apprentis des métiers ci-après mentionnés: Briqueteur-macon : 1ère année.$1.15 $1.15 2ème année.L .25 1.25 3ème année.1.35 1.35 Charpentier-menuisier: 1ère année.1.10 1.15 2ème année.1.15 1.20 3ème année.125 1.30 lème année.1.35 l .40 Electricien: 1ère année.1 10 1.15 2èmc année.1.15 1.20 3ème année.1.25 1.30 lème année.1.35 1 .40 Fer ornemental: 1ère an née.1.05 1.05 2ème année.1.10 1.10 3èmc année.1-20 1.20 4ème année.1.30 1 30 Lettreur pour fins commerciales: 1ère année.1.10 1.10 2ème année.1.15 1.15 3ème année.1.30 1.30 4ème année.1.40 1 .40 Mécanicien en tuyauterie, ferblantier, plombier: 1ère année.1 05 1.10 2èmc année.115 1.20 3ème année.1 \u2022 25 1.30 lème année.1.35 1 .40 Poseur de brûleur à l'huile: 1 ère année.1 \u2022 30 1.40 Poseur de tuile, terrazzo, marbre et couvre-plancher: 1ère année.1-05 1.05 2èmc année.1.10 1.10 3ème année.120 1.20 4ème année.1 - 30 1.30 llourlji rates From .I pr il 1st.I960 Mastic lloor laver.$1 .80 $1 .80 Tile, asphalt and terrazzo layer 1.80 1.80 Marble layer.1.80 1.80 Steam or gasoline mixer operator.1.50 1.50 Pile driver (wood or concrete) 1.45 1.45 Mixer operator (electrical - or small mixer).1 .40 1.40 Kettleman (flooring only).1 .40 1.40 Terrazzo polishing machine operator.1.50 1 .50 Crane operator.1.50 1.50 Power shovel operator.1.85 1.85 Piping, caulking, welding .1.30 1.30 Compressor operator.1.50 1.50 Asphalt raker .1.30 1.30 Pipe welder (acetylene or electricity) .1.90 2.00 Watchman, also employed as fireman and required to hold 4th class certificate.1.38 1.38 Ornamental iron worker.1.30 1.30 Job watchman (per week).55.00 00.00 /;) Minimum wages of apprentices: The following minimum wages shall he paid to apprentices in the following trades: Bricklayer mason : 1st year.$1.15 $1.15 2nd year.1.25 1.25 3rd year.135 1.35 Carpenter - joiner: 1st year.1.10 1.15 2nd year.1.15 1.20 3rd year.1.25 1.30 4th year.1.35 1.40 Electrician : 1st vear.110 115 2nd year.1.15 1.20 3rd vear.1.25 1.30 4th year.1.35 1.40 Ornamental iron: 1st vear.1.05 1.05 2nd\" vear.1.10 1.10 3rd vear.1.20 1.20 4th Vear.130 1.30 ( Commercial letterer: 1st vear.1.10 1.10 2nd vear.1.15 1.15 3rd vear.1.30 1.30 4th year.1.40 1.40 Pipe mechanic.Tinsmith.Plumber: 1st vear.1.05 1.10 2nd vear.1.15 1.20 3rd vear.1.25 1.30 4th Vear.135 1.40 Oil Burner Mcchanci: 1st year.130 1.40 Tile, terrazzo.marble and oilcloth lavcr: 1st year.1.05 1.05 2nd year.1.10 1.10 3rd vear.120 1.20 4th vear.,.1.30 1.30 2694 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql ÉIIFA ', Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 Taux horaires A compter du 1er avril I960 Peintre: 1ère année.2ème année.3ème année.4èine année.Plâtrier: 1ère année.2ème année .3ème année.Per d'armature: 1 er semestre.2ème semestre.Painter: 1.05\t«1\t05\t1st year.1.10\t1\t10\t 1.15\t1\t15\t 1.25\t1\t25\t4th year .\t\t\tPlasterer: 1.10\t1\t10\t1st year .1.20\t1\t20\t2nd year.1.30\t1\t30\t3rd year .\t\t\tReinforcing steel: 1.50\t1\t05\t1st six months.1.65\t1\t85\t2nd six months.Hourly rates From April 1st, I960 05\t$1\t05 10\t1\t10 15\t1\t15 25\t1\t25 10\t1\t10 20\t1\t20 30\t1\t30 50\t1\t65 05\t1\t85 h) Frais de déplacement et repas: Les frais de déplacement des salariés envoyés en dehors de la municipalité où l'employeur a sa place d'affaires sont à la charge de l'employeur et le salaire du salarié ne doit pas être réduit.De plus, le repas du midi est à la charge de l'employeur au taux fixe de 81.50 du repas si le salarié n'a pas été averti la veille.\" 2° Les paragraphes \"b\" et 'V de l'article IX sont remplacés par les suivants: \"b) Taux de salaires minima: Les taux de salaires suivants doivent être payés: Salaire hebdomadaire Ouvrier de métier qualifié ou homme de métier.8(55.00 Journalier (ouvrier non qualifié).50.00 e) Les salariés permanents préposés à l'entretien recevant un salaire annuel d'au moins 82.500.00.et qui, à cause de la nature de leur emploi sont requis de répondre à des appels urgents en tout, temps du jour ou de la nuit pour la protection d'édifices ou d'immeubles, sont par la présente exemptés des taux de salaires pour travail supplémentaire.\" 3° Le paragraphe \"o\" de l'article X est remplacé par le suivant: \"X.Dispositions relatives à l'apprentissage: a) Aucun apprenti, dans l'un ou l'autre des métiers de la construction mentionnés à l'article V, ne doit commencer son apprentissage avant d'avoir 16 ans révolus ou après avoir dépassé 25 ans.Il doit de plus avoir terminé sa 7ème année du cours primaire.Toutefois, le comité paritaire, sur requête de l'apprenti intéressé et avec la recommandation de l'organisation professionnelle à laquelle celui-ci appartient, peut admettre à l'apprentissage un candidat âgé de plus de 25 ans qui, pour des raisons graves n'a pu commencer son apprentissage avant cet.âge.\" 4° L'article XV est remplacé par le suivant: \"XV.Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 1961.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 1er avril de l'année 1901 et de toute année subséquente.Un tel avis doit également êgre adressé au Ministre du Travail.\" L.DÉSILETS.5087G-o Greffier du Conseil Exécutif.//) Travelling expenses and meals: Travelling expenses of employees sent outside the municipality where the employer operates shall be paid by the employer and the employee's wages shall not be reduced.The noon meal shall also be paid by the employer, at the rate of 81.50 per meal, when the employee has not been informed the day before.\" 2.Paragraphs \"6\" and \"e\" of article IX are replaced by the following: \"b) Minimum wage rates: The following shall be the minimum wage rates: Weekly wages Skilled worker.865.00 Common worker.50.00 e) Permanent maintenance men who receive a yearly salary of at least $2.500.00 and who are required to answer emergency calls at any time of day or night for the protection of building property are hereby excluded from overtime rates of wages.\" 3.Paragraphe \"o\" of article X is replaced by the following: \"X.Provisions respecting apprenticeship: a) No apprentice in any one of the building trades mentioned in article V.shall begin his apprenti-ship before 10 or after 25 years of age.Also, he must have completed the 7th year of the Primary Course.However, the Joint Committee, upon request of an apprentice supplemented by the recommendation of the union to which he belongs, may authorize a candidate of more than 25 years of age to begin his apprentice-chip if serious reasons prevented him from doing so before that age.\" 4.Article XV is replaced by the following: \"XV.Duration of.the decree.The present decree remains in force until April 1.1961.It then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary, within the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day before April 1, of the year 1961 or of any subsequent year.Such a notice shall also be given to the Minister of Labour.\" L.DÉSILETS.50876-o Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2695 ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DC CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 614 Section \"C\" Québec, le 18 juin 1959.Présent: Ix: Lieutenant-gouverneur en conseil.CONCERNANT (les modifications au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications au décret numéro 309 (A) du 8 avril 1959, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal; Attendu que ledit avis a été publié clans la Gazette officielle de Québec, édition du 25 avril 1959; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition «le l'honorable Premier Ministre: Que ledit décret, minière» 309 (A), soit modifié comme suit: 1° L'item \"Poseur de lattes en bois, composition .2 années\", apparaissnt à l'article 38, est radié.2° Le paragraphe \"g\" de l'article 39 est radié.L.DÉSILETS, 50876-O Greffier du Conseil Exécutif.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Rarrette.ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Ïah de la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans le district de Saint-François, rendue obligatoire par le décret numéro 255 du 5 mars 1953 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en conseil des modifications audit décret savoir: 1° Les heures de travail déterminées poulies zones II et III, au paragraphe \"a\" de l'article III.seront remplacées par les suivantes: Zone II \"Lundi: de 8.00 a.m.à midi.Mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a-.in.à 6.00 p.m.Vendredi, samedi et veille de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Exceptions: i.Cependant, dans la cité de Lac Mégantic et un rayon de cinq (5) milles de ses limites, les heures de travail sont comme suit: Lundi: de 1.00 p.m.à 0.00 p.m.Mardi, mercredi, jeudi et samedi: 8.30 a.m.à 6.00 p.m.Vendredi: de 8.30 a.m.à 9.00 p.m.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 014 Part \"C\" Quebec, June IS, 1959.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments of the cecree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal.WHEREAS, pursuant to the procedure established umler section 8 of the Collective Arrcement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, ehaptcr 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the decree number 309 (A) of April 8, 1959.relating to the construction industry and trades in the region of Montreal; WnEREAS the said notice ha.s been published in the Quebec Official Gazette, issue of April 26, 1959; WllEREAS no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Prime Minister: That the said decree, number 309 (A), be amended as follows: 1.The item \"Lather, wood and composition .2 years\", appearing in article 38.is deleted.2.Paragraph \"«7\" of article 39 is deleted.L.DÉSILETS, 5087G-O Clerk of the Executive Council.Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 103 and amendments), that contracting parties to the Collective Labour Agreement relating to the barbering and hair-dressing trades in the district of St.Francis, rendered obligatory by the decree number 255 of March 5th.1953 and amendments, have petitioned him to submit to the consideration ami decision of the Lieutenant-Governor in Council certain amendments, to the said decree, to wit: 1.The hours of work determined for zones II and III.paragraph \"«\" of article III.will be replaced by the following: Zone II \"Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon); Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday, Saturday ami holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Exceptions: i.However, in the city of Lac Mégantic ami a radius of five (5) miles from its limits, hours of work shall be as follows: Monday: 1.00 p.m.to 0.00 p.m.Tuesday.Wednesday.Thursday and Saturday: 8.30 a.m.to 6.00 p.m.\"Friday: 8.30 a.m.to 9.00 p.m. 2696\" GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 Les 20.21 et 22 décembre: de 8.30 a.m.à 8.00 p.m.Les 23 et 24 décembre: de 8.30 a.m.à 9.00 p.m.ii.Dans les municipalités de Kock Island, Bêche Plain, Stanstead et un rayon de cinq (5) milles de leurs limites, les heures de travail commencent à 8.30 a.m.tous les jours et se terminent à 6.00 p.m.le lundi, à midi le mardi, à 9.00 p.m.le jeudi et à 0.00 p.m.le vendredi.iii.A East Angus, les heures de travail se terminent à 5.00 p.m.le samedi.Zone III On December 20.21 and 22: 8.30 a.m.to 8.00 p.m.On December 23 and 24:8.30 a.m.to 9.00 p.m.ii.In the municipalities of Rock Island, Beehe Plain, Stanstead and a radius of five (5) miles from their limits, work shall start at 8,30 a.m.every day and shall cease at 0.00 p.m.on Monday at 12.00 (noon) on '1 ucsday.at 9.00 p.m.on Thursday and at 0.00 p.m.on Friday.iii.At East Angus, work shall cease at 5.00 p.m.on Saturday.Zone III Lundi: de 8.30 a.m.à midi.Mardi, mercredi et jeudi: de 8.30 a.m.;\\ 7.00 p.m.Vendredi et veilles de fêtes chômées: de 8.30 a.m.a 10.00 p.m.Samedi: de 8.30 a.m.à 9.00 p.m.\" 2° Ia'h item ci-après mentionnés, apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article VIII, seront remplacés par les suivants: /.ones I II III \"Barbe .80.50 $0.45 80.40 Coupe de cheveux pour adultes des deux sexes: Lundi, mardi, mercredi, jeudi.0.85 0.75 0.70 Vendredi, samedi et veille de fêtes.0.95 0,85 0,80 (\u2022oupe de cheveux pour enfants de moins de 10 ans: Lundi, mardi, mercredi, jeudi.0.50 0.45 0.40 Vendredi, samedi et veille de fêtes.0.05 0.00 0.50 Coupe de cheveux en brosse et Hollywood : Adultes.110 1.00 0.90 Enfants de moins de 10 ans .0.00 0.55 0.50\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'Arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Ix' Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Quéhec, le 27 juin 1959.50870-o Monday: 8.30 a.m.to noon.Tuesday.Wednesday and Thursday: 8.30 a.m.to 7.00 p.m.Friday and holiday eves: 8.30 a.m.to 10.00 p.m.Saturday: 8.30 a.m.to 9.00 p.m.\" 2.The items hereafter mentioned, appearing in paragraph \"a\" of article VIII, will be replaced by the following: Zones I II III \"Shave.$0.50 $0.45 80.40 Haircut, male and female adults: Monday.Tuesday.Wednesday.Thursday .0.85 0.75 0.70 Friday, Saturday and holiday eves, .0.95 0.85 0.80 Haircut \u2014 children under 16 years of age: Monday, Tuesday.Wednesday, Thursday.0.50 0.45 0.40 Friday, Saturday and holiday eves.0.05 O.00 0.50 Brush Cut ami Hollywood: Adults.1.10 1.00 0.90 Children under 10 years of age.0.00 0.55 0.50\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazetfe.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Quebec, June 27.1959.50876-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT NOTICE OF LEVY L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, (pic le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, établi en exécution du décret numéro 505 du 7 mai 1952, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 014 (F) du 18 juin 1959, le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionné: The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Furniture Industry of Quebec, established under decree number 505 of May 7th.1952 has been authorized by by-law approved by Order in Council number 614 (F) of June 18, 1959, in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendment), to levy assessments upon the professional employers and employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Qucbrc.June 27th, 1959.Vol.91.No.20 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet 1959 au 30 juin 1900; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 505 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1/5 de 1% du salaire total payé à leurs salariés régis par le décret, y compris bonis, allocations et commission.b) Les salariés régis par le décret numéro 505 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1/5 de 1% de leur salaire total, y compris bonis, allocations et commission.2.Mode de perception I.Uoij The period of levy shall extend from July \\\\ 1959 to June 30, I960; the levy shall apply as hereinafter ment ioned : a) The professional employers governed by the decree number 505 and amendments, shall pay to the Joint Committee a sum equivalent to 1/5 of 1% of the total wages paid to their employees governed by the decree, including bonuses, allowances ami commissions.b) The employees governed by the said decree, number 505 and amendments, shall pay to the Joint Committee a sum equivalent to 1/5 of 1% of their total wages, including bonuses, allowances and commissions.2.Mode of collect ion En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels, des formules de rapport, lesquelles doivent être remplies selon les règlements du Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce\" (pie ces rapports soient transmis au Comité paritaire tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine à même le salaire de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire, à titre «le prélèvement.Ix; rapport de l'employeur professionnel, accompagné des cotisations doit être signé devant témoin et adressé au Comité paritaire dans un délai de quinze (15) jours après l'expiration «le la période pour laquelle il est exigible.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars.30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie du Meuble de Québec, à compter du 1er juillet 1959 au 30 juin 1960.Le Comité Paritaire de l'Industrie du Meuble de Québec Étal des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er juillet 1959 et le 30 juin 1960.H ec et tes: Estimé des gages pour l'année .810.000.000.00 Cotisations (1/5 de 1%): Employeurs.32.000.00 Salariés.32.000.00 Amendes et pénalités.3.300.00 Revenus divers.800.00 868.100.00 Déboursés: Salaires: Employés.833,800.00 Secrétaire.5,200.00 Frais de vérification.400.00 Frais de voyage: Délégués.13,200.00 Inspecteurs.5,000.00 Loyer.2,400.00 Taxe d'eau et affaires.64.00 Frais légaux.1,000.00 In order to facilitate the collection of these assessments, the Rarity Committee supplies the professional employers with report forms which shall be filed according to the by-laws of the Committee.The professional employer shall see to it that these reports be forwarded to the Rarity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments, owed to' the Rarity Committee.The report of the professional employer, together with the assessments, shall be signed and witnessed before it is sent to the Parity Committee no later than fifteen (15) days after the expiration of the period for which it is exigible.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Joint Committee shall submit a quartely report, of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31.June 30.September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Furniture Industry of Quebec, for the period extending from July 1.1959 to June 30.1960.Joint Committee of the Fuknituke Industry of Quebec Estimated budget for the pcri«xl extending from July 1.1959 to June 30.1960.Receipts: Estimate of Annual Wages: .810.000.000.00 Assessment (1/5 of 1%): Professional employers.32,000.00 Emplovees.32,000.00 Penalties.3,300.00 Miscellaneous.800.00.868,100 00 Disbursements: Salaries: Employees .$33.800.00 Secretary.5.200.00 Audition.400.00 Travelling expenses: Representatives.13,200.00 Inspectors.5,000.00 Rent.2.400.00 Water and Business Taxes.M.00 Legal Fees.1.000 00 2698 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quêlxc, 27 juin 1959.Tome 91, N° 26 Timbres-poste'.8 720.00 Téléphone et télégrammes.350.00 Frais bancaires.320.00 Assurance chômage.290.00 Dépréciation.1.000.00 Papeterie et impressions.2,000.00 Frais généraux.780.00 Assurance groupe.466.00 Achat d'équipement.1,000.00 Mauvaises créances.110.00 808.100.00 Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 27 juin 1959.50870-n AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes ((lie le Comité conjoint de l'industrie de la peinture, établi en exécution du décret numéro 299 du 5 avril 1956, a été autorisé'par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 614 (E) du 18 juin 1959, lequel remplace celui approuvé par l'arrêté en conseil numéro 309 (H) du 8 avril 1959.le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941.chapitre 103 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, dés artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: I.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet 1959 au 1er juillet 1900; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: o) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 299 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente a 1/8 de 1% des salaires fixes, pourcentages, bonis et allocations payés à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 299 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1/8 de 1% du salaire établi pour le salarié compagnon le moins rémunéré, soit 81.35 l'heure (salaire minimum fixé par le décret).c) Ia'S salariés régis par le décret numéro 299 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalent à 1/8 de 1% de leur salaire fixe, pourcentage, bonis et allocations.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les heures de travail, l'argent perçu au cours de la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire à tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même, le salaire de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce comité a le pouvoir d'exiger l'asser-inentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Postage.$ 720.00 Telephone and telegrams.350.00 Bank charges.320.00 Unemployment insurance.290.00 Depreciation.1.000.00 Stationary and printing.2.000.00 General expenses.780.00 Group insurance.466.00 Purchase of equipment.1,000.00 Bad debts.110.00 $08,100.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of La hour, Quebec.June 27.1959.50S76-O NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Paint Industry, formed under decree number 299 of April 5th, 1956, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 614 (E) of June 18, 1959, which replaces the one approved by Order in Council number 309 (H) of April 8, 1959, in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec.1941, chapter 103 and amendments), to collect, levies from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned.i I.Levy The period of levy shall extend from July 1, 1959 to July 1, 1900; it shall apply as hereinafter mentioned: a) The professional employers governed by the decree number 299 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/8 of 1% of the fixed wages, commissions, bonuses, allocations paid to their employees subject to the said decree.b) The artisans governed by the decree number 299 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/8 of 1% of the wages fixed for the least remunerated journeyman, i.e.$1.35 per hour (minimum wage rate fixed by the decree.) c) The employees governed by the said decree number 299 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/8 of 1% of their fixed wages, commissions, bonuses and allocations.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these levies, the Parity Committee shall furnish the professional employers with printed forms indicating the hours of labour, the money collected during the week and the sums owed to the Parity Committee.The professional employer shall have these reports made and returned to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect at the end of every week, from the wages of every one of his employees, the sums owed to the Parity Committee.The report of every professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.This Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 19Ô9, Vol.91, No.26 2099 3.Rapport financier Selon les termes de la Loi de la eon vent ion collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars.30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés probables du Comité Conjoint de l'Industrie de la Peinture, pour la période comprise entre le 1er juillet 1959 et le 1er juillet I960'.3.Financial report ¦ Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Annexed hereto is an estimate of the receipts and disbursements required by the Joint Committee of the Paint Industry for the period between July 1.1959 and July 1, 1900.Le Comité Con hunt dk l'Industrie de la Peinture 3,600 rue Barclay, Chambre 400, Montréal État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er juillet 1959 et le 1er juillet 19(50.Recettes: Cotisations (1/8 de 1%): Employeurs professionnels.$3,750.00 Salariés.3.750.00 $7.500.00 Déboursée: Services du Comité Conjoint des matériaux de construction (12 mois à $420.00).$5.040.(M) Frais judiciaires et professionnels.500.00 Dépenses îles membres y compris les jetons de présence.1.950.00 Impressions et papeterie.150.00 Divers.450.00 $8,090.00 Déficit prévu .590.00 $7,500.00 lie Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail.Québec, le 27 juin 1959.50876-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire du commerce, région du Lac St-Jean, établi en exécution du décret numéro 70 (B) du 29 janvier 1959.a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 014 (G) du 18 juin 1959, le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 103 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation The Joint Committee of the Paint Industry 3,000 Barclay Street, Room 400.Montreal.Estimate of receipts and disbursements for the period between July 1, 1959 and July 1, 1960.Receipts: Levies (1/8 of l%): Professional employers.$11750.00 Employees.3.750 00 17,500.00 Disbursements: Services from the Building Materials Joint Committee (12 months at $420.00 per month).$5,040.00 Legal and professional exj>enses.500.00 Representatives' expenses including attendance fees.1.950.00 Printing and Stationery.150.00 Sundry expenses.450.00 $8.090.00 Estimated deficit.590.00 $7,500.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of labour, Quebec.June 27, 1959.50870-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that I*e Comité Paritaire du commerce, région du Lac St-Jean, formed under decree number 70 (B) of January 29, 1959, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 014 (G) of June 18, 1959, in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 1(53 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans ami the employees- governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned.1.Assessments La période de cotisation s'étend du 3 mai 1959 au 2 janvier 1960; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 70 (B), doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Vi de 1% de leurs listes de paye.b) Les artisans régis par le décret numéro 70 (B), doivent verser au Comité paritaire une The period \"of levy extends from May 3, 1959 to January 2.1960 and applies as follows: a) Professional employers governed by the .decree number 70 (B), shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi of 1% of their payroll.b) Artisans governed by the decree number 70 (B), shall pay to the Parity Committee a sum 2700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 19Ô9, Tome 91, N° 20 somjne équivalente à 14 de 1% du salaire établi dans ledit décret pour le salarié le moins rémunéré, suivant leur emploi.c) Les salariés régis par le\" décret numéro 70 (B), doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 14 surrender its charter umler the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 25th day of June, 1959.LIVERMAN, BRISKIN & YANOFSKY.Attorneys f«>r Solid Glove Limited.145(1 City Councillors.Suite 950.Montreal, Quebec.50804-o Notice is given that, according to the requirements of the Quebec Companies' Act.\"Albert Robert Limitée\", applies to the Attorney General for permission to surrender its charter.ALBERT ROBERT.50895 President.The Sherbrooke Apartments Limited Notice is hereby given that \"The Sherbrooke Apartments Limited\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Datedxat Montreal, this '2,2nd day of May.1959.(Seal) PHILIP F.VINEBERG, 50896-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2705 Suburban Enterprises Inc.Avis est, par les présentes, donné que lu compagnie \"Suburban Enterprises Inc.\".constituée en corporation en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission «l'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi «les compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 16e jour de mai 1959.(Sceau) lie Secrétaire, 50897 PHILIP P.VINEBERG.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.400-59) Avis est, par les présentes, donné que \"('.W.Fuelling, Inc.\", une compagnie à l'omis social étrangère, constituée en corporation en vertu de \"The Indiana General Corporation Act\", a «Hé autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions «le la Iioi des compagnies à fonds social étrangères.S.R.Q.1941.chapitre 279.Le bureau principal «le ladite compagnie dans la province sera établi à chambre 300, 455 ouest, rue Craig, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins «le recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle, est W.H.Laidley, C.R,.de ladite cité de Montréal.Donné au bureau «lu Secrétaire de la province, ce 19e jour «le juin 1959.lie Sous-secrétaire de la province.50866 RAYMOND DOUVTLLE.Département des Affaires municipales Canada, Province de O.GAGNON ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef «lu Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Saut: LETTRES PATENTES Attendu «pic.sous l'autorité de la Loi «les cités et villes (Statuts refondus.1941.chapitre 233).le conseil municipal du village de Pointe-à-Gatineau, dans le comté de Hull, Nous a présenté, conformément à une résolution régulièrement adoptée à sa session du 19 mars 1959, une \u2022 requête demandant que le territoire de ladite municipalité «lu village «le Pointe-à-Gati-neau, tel que décrit dans la description officielle du département des terres et forêts, en date du 16 avril.1959.soit érigé en une municipalité de ville, comprenant six quartiers, numérotés de 1 à 6, chaque quartier étant représenté par un échevin.Suburban Enterprises Inc.Notice is hereby given that \"Suburban Enterprises Inc.\", a corporation constituted-under the Quebec Companies' Act and having its head office in tin- city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the.Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this Kith dav of May, 1959.(Seal) PHILIP F.VINERERG.50S97-o Secretary.Company Licensed to do Business i P.Sec.400-59) Notice is hereby given that \"('.W.Fuelling, Inc.\", an extra-provincial company incorporate«l in virtue of \"The Indiana (ïeneral Corporation Act\", has been licensed t«> carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 279.The principal office of the said company in the Province is to be established at Room 300.455 Craig Street, West, in the city ami judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.W.H.Laidley, Q.C., of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th dav of June.1959.RAYMOND DOUVTLLE, 50866-o Assistant Provincial Secretary.Department of Municipal Affairs Canada.Province of O.GAGNON Quebec.[L.S.J ELIZABETH THE SECOND, by the Grace'of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these letters patent shall come of whom the same may anywise concern.Greeting: LETTERS PATENT Whereas, imdei the authority of the Cities and Towns Act (Revised Statutes 1941, chapter 233), the Municipal Council of the village of Pointe-à-Gatineau, in the county of Hull, has submitted to Us, pursuant to a resolution adopted at its sitting of March 19, 1959, a petition re-questing that the territory of the said municipality of the village of Pointe-à-Galineau, as described in the official description of the Department of Lands and Forests, dated April 16, 1959.be erected into a town municipality, comprised of six wards, numbers 1 to 6, each ward being represented by an Alderman; 2706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, Nc 26 Attendu que la population de la municipalité du village de Pointe-à-Gatineau est de six mille cent quarante-huit âmes; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la Loi des cités et villes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ériger, par lettres patentes, le territoire d'une municipalité de village en municipalité de ville, s'il contient une population d'au inoins deux mille âmes; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête du conseil municipal du village de Pointe-à-Gatineau.A ces ('aises.Sachez que, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 597, en date du 10 juin 1959.et conformément aux dispositions de la Loi des cités et villes.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons: Que le territoire suivant, à savoir: Le territoire actuel de la municipalité du village de Pointe-à-Gatineau, comprenant, en référence au cadastre officiel dudit village, tous les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, ruelles, emprises de chemin de fer, rivières, cours d'eau ou parties d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant du point «l'intersection de la ligne separative des cantons de Hull et de Tempïeton avec la rive gauche ou rive nord de la rivière Ottawa; de là.successivement, les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne separative des cantons de Hull et de Tempïeton jusqu'à la ligne nord du lot 585; ladite ligne nord du lot 585 prolongée à travers le N° 30 (emprise de chemin de fer) et la ligne nord des lots 584 et 504, lesdites lignes faisant le côté nord de la route de La Savannc jusqu'au coin sud-est du lot 42; le prolongement des lignes séparatives des lots 12 et 43 à travers la route de La Savannc; la ligne est des lots 58-2, 58-1.540-25; une ligne traversant la rue St-I^ouis jusqu'au coin nord-est du lot 547-8; la ligne est du lot 547-8 et «lu lot 547 prolongée à travers une rue; la ligne est des lots 548, 549 et 553; cette dernière prolonge jusqu'à la ligne interprovinciale dans la rivière Ottawa: ladite ligne interprovinciale dans la rivière Ottawa dans des directions sensiblement sud-ouest et ouest jusqu'au prolongement de l'axe de la rivière Gatineau; ledit prolongement et ledit axe «le la rivière Gatineau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons «le Hull et «le Tempïeton, et enfin ce «lernier prolongement jusqu'au point de déjMirt; soit érigé en une municipalité «le ville, sous le nom de \"ville de Pointe-Gatineau\"; Que cette municipalité soit divisée en six (piartiers.numérotés «le 1 à G.chaque quartier étant représenté par un échevin et que, par conséquent, le conseil «le ladite municipalité soit composé d'un maire et de six échevins; Que l'endroit de la première session générale «lu conseil «le cette municipalité soit le lieu connu comme étant la salle municipale de Pointe-Gatineau, dans la«lite ville «le Pointe-Gatineau.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et «Je se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable ONÉSIME GAGNON, C.P., C.R., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Whereas the population «jf the municipality of the village of Pointe-à-Gaiineau is six thousand six hundred and forty-eight souls; Whereas in accordance with the provisions of section 12 of the Cities and Towns Act.the Lieutenant-Governor in Council may.by letters patent, erect the territory of a village municipality, into a town municipality if it contains a population of at least two thousand souls; Where it is deemed expedient to grant sai«l petition of the Municipal Council of the village of Pointe-à-Gatineau.Therefore, Known Ye that with the consent ami advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 597.dated June 10, 1959, ami pursuant to the provisions of the Cities and Towns Act, We have enacted ami ordained and do hereby enact and ordain: That the following territory, to wit: The present territory of the municipality of the village of Pointe-à-Gatineau, comprising, with reference to the official «'a«laster of the said village, all the lots or parts of lots and their present and future subdivisions, as well as the roads, streets, lanes, railway rights-of-way.rivers, water-courses, or part thereof, enclose«l within the following limits, to wit: starting from the intersection point of the dividing line of the townships of Hull and Tempïeton with the left bank or North bank of the Ottawa River; thence, the following lines and demarcations: the said dividing line of the townships of Hull and of Tempïeton to the North line of lot 585; the said North line of lot 585 prolongated across No.30 (railway right-of-way) and the North line of lots 584 and 504.the said lines forming the North side of the La Sa vanne Road as far as the southeast corner of lot 42; the prolongation of the dividing lines of lots 42 and 43 across the Savannc Road; the East line of lots 58-2, 58-1, 546-25; a line crossing St-Louis Street to the northeast comer of lot 547-8; the East line of lot 547-8 and «)f lot 547 prolonged across a street; the East line of lots 548.549 ami 553; this latter line prolonged to the interprovincial line in the Ottawa River; the said interprovincial line in the Ottawa River in the obviously southwesterly and westerly directions to the prolongation of the axis of the Gatineau River; the said prolongation and the said axis of the Gatineau River by ascending its course to the prolongation of the dividing line of the townships of Hull and of Tempïeton, and finally this latter prolongation to the starting point: be erected into a town municipality, under the name of \"Town of Pointe-( iatineau\" ; That this municipality be divided into six wards, number from 1 to 6.each ward being represented by an alderman ami that, therefore, the Council of the said municipality be composed of a mayor ami six aldermen; That the first, general meeting of the Council of this municipality be the place known as the Municipal Hall of Pointe-Gatineau, in the said town of Pointe-Gatineau.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern arc hereby required to take notice an«l to govern themselves accordingly.In testimony whereof We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable ONÉSIME GAGNON, P.C., Q.C., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1969, Vol.91, No.26 2707 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de.Noire province de Québec, ce dix-neuvième jour de juin en l'année mil neuf cent cinquante-neuf de l'ère chrétienne et «le Notre Règne la huitième année.Par ordre, lx> Sous-secrétaire de la province, RAYMOND DOUVTLLE.Avis de l'émission des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions «le l'article 15 «le la Loi «les cités et villes (S.R.Q.1941, chapitre 233).Le Ministre des Affaires municipales, 5090G-o PAIL DOZOIS.Département, de L'Instruction Publique N° 508-59.Demande est faite de changer le nom «le la municipalité scolaire de Pascalis, dans le comté d'Abitibi-Est, en celui de Perron, même comté.Québec, le 10 juin 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50803-25-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 379-59.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire de Pascalis, dans le comté d'Abitibi-Est, le territoire ci-dessous décris, qui n'est pas encore organisé au point «le vue scolaire.1.Cette partie du canton Rourlamaque, dans les rangs 1 à 10 inclusivement, comprenant une lisière de terrain limités à l'ouest, par une ligne imaginaire étant le prolongement de celle passant entre les lots 50 et 51 du canton Senneville et bornée à l'est par la ligne separative des cantons Bourlamaque et Louvicourt.2.Les cantons Louvicourt, Vauquelin, Ville-bon, Marias, Fréville et Granet.Québec, le 18 juin.1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50864-25-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 614-53.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date «lu 10 juin 1959.de détacher «le la municipalité scolaire «le Nédelec.dans le comté de Témiscamingue, les lots 481 à 485 inclusivement, les lots 497.498 et 499.«lu cadastre officiel du canton Nédelec, pour les annexer à la municipalité scolaire «le Notre-Dame-du-Nord.même comté.Ce changement prendra effet le premier juillet 1959.Québec, le 19 juin 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50890-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 1032-50.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date «lu 10 juin 1959.d'annexer à la municipalité scolaire de Lac-Labelle, dans le comté «le Libelle, les lots 11 à 20 inclusivement des rangs B et C du canton La-belle, qui ne sont pas encore organisés au point de vue scolaire.Ce changement prendra effet le 25 juin 1959.Québec, le 18 juin, 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique.50890-o O.J.DÊSAULNIERS.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of June in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-nine and the eighth of Our Reign.By Command.RAYMOND DOUVILLE.Assistant-Secretary of the.Province.Notice of the issuance of the above Letters Patent is given in accordance with the provisions of section 15 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1941, chapter 233).PAUL DOZOIS.50900 Minister of Municipal Affairs.Department of Education No.5G8-59.Application is made to change the name of the school municipality of Pascalis, in the county of Abitibi-East.into that of Perron, same county.Quebec.June 10, 1959.O.J.DÊSAULNIERS, .50803-25-2 Superintendent of Education.No.379-59.Application is made to annex to the school municipality of Pascalis, in the county of Abitibi-East.the territory herebelow described, which is not as yet organized from an educational point of view.1.That part of the Bourlamaque township in ranges 1 to 10 inclusively, comprising a strip of land limited on the West by an imaginary line being the prolongation of the line passing between lots 50 and 51 of the Senneville township and bounded on the East by the dividing line of the Bourlamaque ami Louvicourt townships.2.The Louvicourt, Vauquelin, Villebon, Marias, Fréville and Granet townships.Quebec.June 18.1959.O.J.DÊSAULNIERS.50864-25-2 Superintendent of Education.No.614-53.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 10.1959, has been pleased to detach from the school municipality of Nédelec, in the county of Témiscamingue, lots 481 to 485 inclusive, lots 497.498 ami 499.of the official cadaster of the township of Nédelec.to annex them to the school municipality of Notre-Dame-du-Nord, same county.This change will take effect on July first.1959.Quebec, June 19.1959.O.J.DÊSAULNIERS.50890 Superintendent of Education.No.1032-56 His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 10.1959, has been pleased to annex to the school municipality of Lac-Labelle, in the county of Labelle, lots 11 to 20 inclusively of ranges B and C of the Labelle township, which are not as yet organized from an educational point of view.This change will take effect on June 25.1959.Quebec, June 18.1959.O.J.DÊSAULNIERS, 50890 Superintendent of Education. 2708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 19Ô9, Tome 91, N° 26 N° 423-59.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en 'conseil, par arrête en consr-il en date du 10 juin 1950, d'ériger une nouvelle municipalité scolaire, poulies contribuables catholiques seulement, 8 ms le nom Lac-Bouchctte catholique, dans le co nté de Roberval, qui comprendra le territoire actuel des municipalités scolairesdeSt-Thomas-d'Aquin, Lac-des-Commissaires et village du Lac-Rou-clictte, même comté.Ce changement prendra effet le premier juillet 1959.Québec, le 18 juin 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50S90-o O.1.DESAULNIERS.N° 120S-57.Il a plu au Lieutcuaiit-gouvcrueur en conseil, par arrêté en conseil eu date du 10 juin 1959.d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de la paroisse de Berthier, dans le comté de Berthier.à la municipalité scolaire de la ville de Berthier, même comté.Ce changement prendra effet le premier juillet 1959.Quéhec, le 1S juin.1959.Le Surintendant de l'Instruction publique.50890-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 37-50.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date du 10 juin 1959.«l'annexer à la municipalité scolaire du village de Nominingiie.dans le comté «le Libelle, le territoire «lu canton Montigny, lequel n'est pas encore organisé au point «le vue scolaire.Ce chang.'inent prendra effet le 25 juin 1959.Québec, le 19 juin.1959.IiC Surintemlant de l'Instruction puhlupic, .50890-0 O.J.DESAULNIERS.\\'° 784-58.Il ap lu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date «lu 10 juin 1959.«l'ériger une nouvelle municipalité scolaire «lis-tincte.pour les contribuables catholiques seulement, sous le nom «le St-Jean L'Evangéliste catholique, dans le comté «le Rouyn-Noranda, «pii comprendra le territoire actuel «les municipalités scolaires catholiques «le St-Louis-de-Joannès et «le McWatters.dans le même comté.Ce changement prendra effet le premier juillet 1959.Québec, le 18 juin, 1959.Ix! Surintendant de l'Instruction publique, 50890-o 0 J.DÊSAULNIERS.N° 580-50.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil en date «lu 10 juin 1059, «le détacher de la municipalité scolaire de Kensington, dans le comté de Gatineau, le territiore ci-dessous décrit, pour l'annexer, pour les c«)iitri-buablcs catholiques seulement, à la municipalité scolaire «le Ste-Thèrèse, même comté, les lots 1 à 15 inclusivement rang I, et II, 1 à 21 inclusivement rang III.1 à 20 inclusivement rang IV a VIII aussi inclusivement, tous du cadastre officiel du canton Kensington.Ce changement prendra effet le premier juillet 1959.Québec, le 18 juin, 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 50890-o O.J.DÊSAULNIERS.No.423-59.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 10.1959.has been pleased to erect a new shcool municipality for Catholic only, umler the name of Catholic Lac Bouchette, in tin- «\u2022ounty of Roberval, which will comprise the present territory of the school municipalities of St-Thoinas-d'Aquin, Lac-des-Commissaiies ami the village of Lac-Bouchette, same e«unty.This change will take effect on July first, 1959.Quebec, June 18, 1959.O.J.DESAULNIERS.50890 Superintdcnt of Education.No.1268-57.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated June 10.1959.has been pleased to annex the present territory of the school municipality of the parish of Berthier, in the county of Berthier, to the school municipality of the town of Berthier.same «\u2022ounty.This change will take effect on July 1st, 1959.Quebec, June 18.1959.O.J.DESAULNIERS, 50890 Superintendent «>f Education.No.37-50.\u2022 His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by ()r«ler in Council «late«l June 10, 195!), has been pleased to annex to the school municipality of the village of Momininguc, in the county of Labelle, the territory «>f the Montigny township, which is not as yet or-ganissed from an e«lucational point of view.This change will take effect on June 25, 1959.Quebec.June 19.1959.O.J.DESAULNIERS.50890 Superintendent of Education.No.784-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by onler in council dated June 10.1959, has been pleased to erect a separate school municipality, for Catholic ratepayers only, umler the name of St.Jean l'Évangéliste eatholitpue, in the county of Rouyn-Noranda, which will in-clude the present territory of the two Catholic School Municipalities of St.Louis-dc-Joannès and McWatters, in the same county.This change will take effect on July first, 1959.Quebec, June 18, 1959.0.J.DESAULNIERS, 50800 Superintendent of Education.No.580-56.His Honour, the Lieutenant-Governor in council, by Order in council dated June 10, 1959, has been pleased to detach from the Sch«x>l Municipality of Kensington, county of Gatineau, the territory hereinunder described, in order to annex it.for Catholic ratepayers only, to the School Municipality of Ste.Thérèse, same county: lots 1 to 15 inclusively, ranges I and II; 1 to 21 inclusively, range III; 1 to 20 inclusively, ranges IV and VIII also inclusively, all of the official cadaster of the township of Kensington.This change will take effect on July first, 1959.Quebec, June 18.1959.O.J.DESAULNIERS, 50890 Superintednent of E«lucation. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2709 Lett res patentes Hôpital du Snrré-Cu>ur do Hull Avis est donné qu'en vertu «les dispositions de l'article 14 de la Loi modifiant la charte «le la Commuanuté «les Sœurs de Charité «le la Providence, 7-8 Elizabeth II, chapitre 170.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Quéhec des lettres patentes, en date «lu six mai 1959.constituant en corpora ion l\"*IIôpital «lu Sacré-( !œur «le Hull\".Le siège social «le la corporation ci-haut mentionnée est situé dans la ville mbourg, comté «l'Abitibi, le 1er février 1959, il a été résolu «pie les affaires de ladite société soient liquidées volontairement, et que celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi «les syndicats coopératifs Notice of Liquidation of \"La Compaonik d'Assuranck Mutuelle contre le feu de la paroisse DE St-HuBERt\" Notice is hereby given, as provided in section 270 «)f the Quebec Insurance Act, that \"La Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le feu de la paroisse de St-Hubert\", at a special general meeting of its members held on June 11th 1959.has i I) decided to Jupiidatc its business.(2) named as liquidât m- Mr.Emile Bouthiliier domiciled at St.Hubert, and (3) fixed the 21st of June as the date upon which its policies will cease to be in force.Given at St.Hubert, this 11th dav of June 1959.EMILE BOUTHILLIER.50870-20-2-o Secretary.Notice of Appointment of the Liquidator of \"La Co.mpaonik d'Assuranck Mutuelle contre LE peu de LA paroisse de St-HuBERT\" Notice is hereby given that on the llth of June 1959 at a special general meeting of the members of \"La Compagnie «l'Assurance Mutuelle contre le feu de la paroisse «le St-Hubert\".the undersigned, domiciled at St.Hubert, was appointed liquidator of the affairs «)f the said company pursuant to the provisions of section 270 of the Quebec Insurance Act (Chapter 299).Any claim against the said company must be sworn to and filed with me within the thirty days following the present notice.Given pursuant to article 872 of the Code of Civil Procedure, this llth day of June 1959.ÊMILE BOUTHILLIER.50871-O Liquidator.Notice is given that a special general meeting of members of \"La Caisse Populaire de Ste-Clairc de Colombourg\", held at Saintc-Cliurc-de-Coloinbourg, county of Abitibi.on February 1st, 1959, it has been resolved that the affairs of said association be voluntarily wound up, and that said association be dissolved, pursuant to the provisions of the Quebec Cooperative 2710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91.N° 26 de Québec et de la Ix>i de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, et que M.Maurice l'erreault a été nommé liquidateur.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix-huit juin 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 50905-o RAYMOND DOUVILLE.Proclamation Canada.Province de O.GAGNON Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou «pi'icelles pourront concerner.Salut.PROCLAMATION L* Assistant-procureur i ATTENDU que, sous général.) l'autorité des dispo- C.E.Cantin.\\ sitions de l'article 2 de la ( loi relative aux titres de propriété dans la Gaspésic et le district électoral de Saguenay (12 George VI.chapitre 37 et 14-15 George VI.chapitre 39), le ministre des terres et forêts a fait dresser des plans etJivres de renvoi revisés des cadastres officiels: 1° de cette partie du canton de Christie, en le comté de (Jaspé-Ouest, comprenant tous les lots du premier rangdudit canton et leurs subdivisions respectives; 2° de cette partie du canton de Duchesnay, comprenant tous les lots du premier rang et les lots 52,-'53 et 54 inclusivement «lu second rang dudit canton avec leurs subdivisions respectives; 3° «le cette partie «lu canton de Tasehereau.comprenant tous les lots «lu premier rang, ainsi que ceux du rang A et leurs subdivisions respectives; 4° de cette partie «le la municipalité de St-Maxime-du-Mont-Louis, comprenant la seignerie «lu Mont-Louis, incluant tous les lots «le ladite seigneurie et leurs subdivisions respectives; Attendu que, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de ladite loi.il a fait déposer: 1° pour le cadastre revisé «!«\u2022 cette partie ci-haut décrite du canton de Christie: a) les originaux des plans et livres «le renvoi revisés, aux archives du département des terres et forêts, le 13 mars 1958; - /;) une copie certifiée des plans et livres «!ec.Daté à Montréal, ce 28e jour de mai 1959.(Sceau) Le Secrétaire, 50902 IRVING EKLOVE.Avis est donné que la compagnie \"Marvel Gauthier Société Incorporée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du quatrième jour de février 1959, et ayant son bureau principal dans Montréal, a établi son bureau au numéro 7939.rue Garnier.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce lôèmc jour d'avril 1959.(Sceau) Le Président, 50903-o MARCEL GAUTHIER.Canada Province de Québec District de Terrebonne Norvic Realties Ltd.Avis est.par les présentes, donné que la compagnie \"Norvic Realtie Ltd.\" constituée en cor-paration, le 13e jour de mars 1959, a établi son siège social sur la Grande Côte, en la ville de Rosemère, en la province de Québec.Montréal, ce 24e jour de juin 1959.Le Secrétaire, 50904 JOHN M.MCDOUGALL.VENTES PAR SHËRIFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnes plus bas.ABITIBI Province de Québec District d'Abitibi Cour Supérieure, i A NTONIO BOUFFARD, N° 9521.\\ **¦ contracteur, domicilié và St-Pierre de Montmagny, district de Montmagny, saisissant, vs LEO BISSON, contracteur, domicilié à Louvicourt, district d'Abitibi, saisi.AVIS DE VENTE L'immeuble connu et désigné conune étant le lot numéro trois cent huit (308) du bloc trente quatre (34) au cadastre officiel pour le canton Bourlamaque, comté d'Abitibi-Est, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Sauveur de Val d'Or, le HUITIÈME jour de JUILLET 1959 à DEUX heures p.m.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 1er juin 1959.50757-23-2-o Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour Supérieure.I p ÉRARD DERASP.co-N° 11.461.\\ Ion, domicilié et de-' meurant à St-Maurice de Dalquier, district d'Abitibi, saisissant; vs CLA-VERNY GOLD MINES LIMITED, n.p.l., cor- tablished its office at Suite 330, 1010 St.Catherine Street W., Montreal.Qucl>cc.Dated at Montreal, this 28th dav of May, 1959.(Seal) IRVING EKLOVE, .50902-0 Secretary.Notice is given that the company \"Marcel Gauthier Société Incorporée,\" incorporated by letters patent dated the fourth day of February, 1959, and having its head office in Montreal, has established its office at number 7939 Garnier Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 15th dav of April, 1959.(Seal) MARCEL GAUTHIER, 50903 President.Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Norvic Realties Lld.Notice is hereby given that \"Norvic Realties Ltd.\" incorporated 13th day of March, 1959, has established its head office on Grande Côte, in the town of Rosemère.in the Province of Quebec.Montreal, this 24th dav of June.1959.JOHN M.MC DOUG ALL, 50904-o Secretary.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province of Quebec District of Abitibi Superior Court, j A NTONIO BOUFFARD, No.9521.\\ contractor, domiciled at v St-Pierre de Montmagny, district of Montmagny, seizing creditor, vs LÉO BISSON, contractor, domiciled at Louvicourt, district of Abitibi, seized.NOTICE OF SALE The immoveable known and designated as being lot number three hundred and eight (308) of block thirty-four (34) of the official cadaster for the township of Bourlamaque, county of Abitibi-East, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of St-Sauveur of Val d'Or, on the EIGHTH day of JULY, 1959, at TWO o'clock p.m.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, June 1st, 1959.50757-23-2 Province of Quebec - District of Abitibi Superior Court.( p ÊRARD DERASP, set-No.11.461.\\ tier, domiciled and re-\\ siding at St-Maurice de Dalquier, district of Abitibi.seizing creditor; vs CLAVERNY GOLD MINES LIMITED, n.p.l., 2716 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Totale 91, N° 26 PC-ration minière légalement constituée et incor- Mining Corporation, legally constituted and porée, ayant son siège social au numéro 6X2 incorporated, having its head office at number Avenue Blooinficld.Montréal, saisi.682.Blooinfield Ave.Montreal, seized.AVIS DE VENTE Les biens immobiliers suivants savoir: Les claims A-52,097, A-52,099, A-52,100 situés sur la demie-sud des lots 22.28 et 25 du rang f lot 138-272.on the southeast side by lot 138-283.above described and on the other side, on the northwest, by the residue of lot 138-282.the said strip of land being known on the official plan and in the hook of reference of the cadaster for the township of Grantham as being the southeast part of lot two hundred and eighty-two of the official subdivision of lot number one hundred and thirty-eight.(138-Pt.S.E.282), with all the buildings thereon erected.To be sold at the parochial church door of St-Simon of Drummond.on the THIRTIETH day of JULY 1959, at THREE o'clock in the afternoon.(Daylight Saving time).FÉLIX HOULE.Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska.this 22nd day of June.1959.50909-26-2 CHICOUTIMI Fieri Facias District de Chicoutimi CHICOUTIMI Fieri Facias District of Chicoutimi District de Roherval.( TVAME Cou.Supérieure.J ±J DUBÉ, J.-M.BEL-N° 22,268.\\ LEY, Naudville.de-'mandeurs; vs DAME GEORGETTE MOREL.LEOPOLD MALTAIS, N.-D.«lu Rosaire, défendeurs, et LEOPOLD MALTAIS.N.-D.du Rosaire.Mis-en-cause.\"Un terrain ou emplacement situé en la paroisse «le Notre-Dame «lu Rosaire, mesurant cinquante pieds (50') de front dans le sens nord-sud, sur cent (100') pieds «le profondeur dans le sens est-ouest, le tout faisant partie du lot numéro trois (Ptie N° 3), aux plan et livre de renvoi officiels pour le cadastre «lu canton Rouleau, dans le premier rang ouest du Lac «les Habitants, et compris dans les bornes suivantes, savoir: Au nord, a l'est et au sud au terrain d'Adrien Tremblay, et à l'ouest au chemin public, ledit terrain étant situé à deux cent pieds de la ligne nord «lu terrain «le Freddy Lapointe ou représentants, le tout avec les bâtisses y érigées, circonstances, et dépendances.\" Pour être vendu à la porte «le l'église à Notre-Dame du Rosaire, le TRENTIEME jour du mois de JUILLET 1959.à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.RENÉ DELISLE.Chicoutimi, le 23 juin 1959.50912-26-2-o PHILIANNE District of Roherval./ TAAMK Superior Court.) No.22.208.PHILIANNE DUBÉ.J.-M.BEL-\\ LEY.Naudville, plain-f tiffs: vs DAME GEORGETTE MOREL.LEOPOLD MALTAIS, N.-D.du Rosaire, defendants and LEOPOLD MALTAIS.N.-D.«lu Rosaire, mis-en-cause.\"A lot of land or emplacement situated in the parish of Notre-Dame «lu Rosaire, measuring fifty feet (50') in frontage in the north-south direction, by one hundred (100') feet in depth in an east-west direction, the whole forming part of lot number three (Ft.No.3), on the official plan and in the book of reference for the cadaster of the Rouleau township, in the first range west of Lac des Habitants and comprised within the following boundaries, to wit: on the north, east ami to the south of the lot of Adrien Tremblay, and on the west of the public highway, the said lain! being situated at two hundred feet of the north line of the land of Freddy Lapointe or representatives, the whole with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the door of the church of Notre-Dame du Rosaire, on the THIRTIETH day of the mounth of JULY, 1959, at THREE o'clock in the afternoon.^ RENE DELISLE, Sheriff's Office.Sheriff.Chicoutimi, June 23, 1959.50912-20-2 2718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 19Ô9, Tome 91, N° 26 GASPÉ Fieri Facias île Terris et de Bonis ( oui- Supérieure, ( C LA VERY & C.LA VERY Montréal.J ^« avocats.1575 rue St-N° 465383.) Denis.Montréal.P.Q., demandeurs, vs PHILIPPE BERTRAND.5736 rue Clark.Montréal, P.Q.Les propriétés à vendre sont les suivantes: \"Un certain morceau de terrain sis et situé à Petite Rivière Ouest, municipalité de Ste-Adélaïde de Pahos, comté de (Jaspé, P.Q.et district de (Jaspé, portant le N° 278.\"Un deuxième lot portant N° 259.avec maisons dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendues à la porte «le l'église «le Ste-Adélalde «le Pabos, MARDI le VINGT-HUITIÈME jour «le JUILLET 1959, à DEUX heures «le l'après-midi.1-e Shérif, Bureau du Shérif, J.E.MEAGHER.Percé, le 22 juin 1959.5091()-2G-2- Fieri Facias de Terris Cour de Magistrat.( \\yf AURICE GOUPIL, Gaspé, ; Chandler, comté de N° 10104.) Gaspé, P.Q.«lemandeur.{ vs Mme Vve JOS.BLAIS.300 Hétu, Gatineau Mills, P.Q., défenderesse.La propriété à vendre est la suivante: \"Une certaine terre sise et située dans la Municipalité de Pahos.mieux connue et désignée aux plan et livre «le renvoi officiels pour ladite municipalité comme étant le lot N° 39 du second rang de la Seigneurie de Pahos.Borné comme suit : au nord le 3ième rang, à l'est par le lot N° 38.au sud par le 1er rang et à l'ouest par le lot N° 40.Pour être vendue à la porte «le l'église «le Ste-Adélaïde de Pabos, MARDI, le VINGT-HUI-TIÈME jour «le JUILLET 1959.à DIX heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.E.MEAGHER.Pereé.le 22 juin 1959.5091 1-20-2-d GASPÉ Fieri Facias de Terris et de Bonis Superior Court.( O LAVERY & C.LA VERY Montreal.J ^» advocates.1575 St.De-No.465383.) nis Street.Montreal.P.Q.( plaintiffs vs PHILIPPE BERTRAND.5736 Clark Street.Montreal, P.Q.The following properties are for sale: \"A certain piece of land situated at Petite Rivière west, municipality of Ste-Adélaïde de Pabos.county of Gaspé.P.Q.and district of (Jaspé, bearing No.278.\"A secoml lot bearing No.259, with houses thereon erected, circumstances and «lependencies.To be sold at the church door of Ste-A«lélaïde «le Pabos.TUESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of JULY.1959.at TWO o'clock in the afternoon.J.P.MEAGHER.Sheriff's Office, \u2022 Sheriff.Percé.June 22.1959.50910-20-2 Fieri Facias de Terris Magistrate's Court, f \"KvTAURICE GOUPIL, Gaspé, ) Chandler, county of No.10104.) (Jaspé, P.Q., plaintiff, vs [ Mrs.widow JOS.BLAIS.300 Hétu, Gatineau Mills, P.Q., defendant.The following property is for sale: \"A certain farm situated in the municipality of Pabos, better known ami designated on the officii! plan and in the book of reference for the said municipality as being lot No.39 of the second range of the Pabos Seigniory.Bounded as follows: on the north, by the 3rd range, on the east, by lot No.38, on the south, by the first range and on the west, by lot No.40.To be sold at the church door of Ste-Adélaïde de Pabos, TUESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of JULY, 1959.at TEN o'clock in the forenoon.J.F.MEAGHER.Sheriff's Office.Sheriff.Percé.June 22.1959.50911 -20-2 JOLIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Cour Supérieure.( T> OSAIRE VACHON, des N° 95786.{ ^ cité et district de Qué-' bec y faisant affaire seul, sous les nom et raison sociale de \"Admiral Stainless Steel Reg'd\", demandeur, vs CLAIRE FER-LAND, épouse de Lucien Arcouette, tous deux de lieux inconnus faisant ci-devant affaires seule tant à Trois-Rivières, Québec et Montréal sous les noms et raison sociale de \"Claire Ferland Fina Ware Enr.\" comme marchande publique avec le consentement de son mari et ce dernier mis en cause pour autoriser et assister sadite épouse aux fins «les présentes, défendeurs.Comme appartenant aux défendeurs: Immeuble situé à St-Gabriel de Brandon et décrit aux plan et livre de renvoi du cadastre (renouvelé) «le St-Gabriel: \"La moitié indivise «l'un emplacement situé à St-Gabriel de Brandon, connu et désigné comme étant une partie «lu lot numéro cinq cent trente-A-douze (P.530-A-12) du cadastre du village de St-Gabriel de Brandon, de la contenance de tout le terrain compris entre le terrain de M.Albertin JOLIETTE Fieri Fadas de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Quebec Superior Court.( T3 OSAIRE VACHON, of No.95786.\\ fV the city and district of I Quebec carrying on business alone, under the name and style of \"Admiral Stainless Steel Reg'd\", plaintiff, vs CLAIRE FERLAND, wife of Lucien Arcouette, both of unknown address, carrying on heretofore business alone as well in Trois-Rivières.as in Quebec and Montreal, under the style and name of \"Claire Ferland Fina Ware Enr.\" as a public merchant with the consent of her husband and the latter m is en cause to authorize and assist his wife for these presents, defendants.As belonging to the defendants: An immoveable situated at St-Gabriel de Brandon and described on the official plan and in the book of reference of the cadaster (renewed) of St-Gabriel : \"The undivided half of an emplacement situated at St-Gabriel de Brandon, known and designate*! as being a part of lot number five hundred an«l thirty-A-twelvc (Ft.530-A-12) of the cadaster of the village of St-Gabriel de Brandon, containing the whole of the land com- QUEHEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2719 DèSTOchers (N° 530-B-l), le terrain de M.Gabriel Lemire (N° 530-B-2), le terrain de la Fabrique de St-Gabriel de Grandon, N° 530-M-l) d'un côté, le terrain de Adélard Houle (N° 529) en arrière, et autre partie duditjot N° 530-A-12 appartenant à Hildège Desroeliers de l'autre côté, et borné en front par la rue St-Gabriel: avec une maison, un restaurant et dépendances dessus construits, et les servitudes existantes, notamment le droit de passage mitoyen avec M.H.Desroeliers.\" Four être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Gabriel de Brandon, le MERCREDI, VINGT-NEUVIÈME jour de JUILLET 1959.à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif de Joliette.Bureau du Shérif, ROLAND PERRAULT.Joliette.22 juin 1959.50913-26-2-o KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour Supérieure, ( pÔTÊ & GODBOUT INC, N° 21066.< ^ corps politique et in-\\ corporé ayant, son siège social à Trois-Pistoles, demandeurs vs JEAN FRAN* ÇOIS MICHAUD, de Rivière-du-Loup, défendeur et J.MAURICE FOISY, en sa qualité de régistrateur pour la division d'enregistrement de Témiscouata (mis en cause).Un terrain situé dans la paroisse de St-Modeste, contenant deux cents pieds de front sur deux cents pieds de profondeur, mesure anglaise, borné au nord à Napoléon Lavoic, au sud et à l'ouest à Joseph Deschênes, ou représentants et à l'est au chemin neuf de Témiscouata; lequel terrain fait partie des lots numéros quarante-un et quarante-deux (41 ptie et 42 ptie) du canton Witworth, dans le cinquième rang sauf à distraire la partie vendue au Ministère de la Voirie, avec les bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Le tout pour être vendus à la porte de l'église de St-Modeste, comté de Rivière-du-Loup, MERCREDI le QUINZIÈME jour de JUILLET 1959 à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif du Bureau du Shérif, district, de Kamouraska, Rivière-du-Loup CYRILLE PELLETIER.ce 30ième jour de mai 1959.50737-23-2-o [Première insertion: samedi le G juin 1959] Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour de Magistrat, / TNAME ALICE FRA-N° 2534.< ¦L-' SER, veuve usant de v.ses droits de feu Hector Prévost, résidant et domicilié à Rivière-du-Loup vs OMER LEBEL, journalier de Rivière-du-Loup.Un terrain situé sur le côté sud de la rue Bellevue, en la cité de Rivière-du-Loup, mesurant cinquante pieds de largeur est-ouest par environ cent dix pieds de profondeur nord-sud, mesure anglaise, tel que borné en front, au nord-ouest à la rue Bellevue; au sud-est; au terrain de Albert Beaulieu, au nord-est au terrain de J.Baptiste Marchand, et au sud-ouest au résidu du terrain de la Dame venderesse, lequel terrain ainsi décrit et borné est une partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent vingt (120) au cadastre officiel pour la ville de prised between the lot of land of Mr.Albertin Desrochers (No.530-B-l).the lot of land of Mr.Gabriel Lemire (No.530-B-2), the lot of land of the Church proprety of St-Gabriel de Brandon, No.530-M-l) on one side, the lot of land of Adélard Houle (No.529) in rear, and the other part of the said lot No.530-A-12 belonging to Hildège Desrochers on the other side, and bounded in front by St-Gabriel Street; with a house, a restaurant and dependencies thereon constructed, and the existing servitudes, notably the mitoyen right-of-way with Mr.H.Desrochers.\" To be sold at the parochial church door of St-Gabriel de Brandon, on WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH day of JULY, 1959.at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERRAULT.Sheriff's Office.Sheriff of Joliette.Joliette.June 22.1959.50913-20-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Superior Court, ( pÔTÊ & GODBOUT INC, No.21066.I body politic and corpo-v rate, having its head office at Trois-Pistoles, plaintiffs, vs JEAN FRANÇOIS MICHAUD, of Rivière-du-Loup, defendant, and J.MAURICE FOISY, in his opacity of registrar for the registry division of Témiscouata (Mis-en-causc).A piece of land situated in the parish of St.Modeste, containing two hundred feet in front by two hundred feet in depth, English measure, bounded northerly by Napoléon Lavoie, southerly and westerly by Joseph Deschônes, or representatives and easterly by the new Témiscouata road; which piece of land forms part of lots numbers forty-one and forty-two (P.41 and P.42) of the township of Witworth, in range five save and except that part sold to the Department of Roads, with the building thereon erected, circumstances and dependencies.All of which to be sold at the door of the church of St.Modeste, county of Rivière-du-Loup, WEDNESDAY the FIFTEENTH day of JULY 1959, at TWO o'clock, in the afternoon.CYRILLE PELLETIER, Sheriff's Office, Deputy^Sheriff of the Rivière-du-Loup, district of Kamouraska.this May 30th, 1959.50737-23-2 [First insertion: Saturday, June 6, 1959] Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Kamouraska Magistrate's Court, ( T^AME ALICE FRA-No.2534.< J-'SER, widow in use of [ her rights, of the late Hector Prévost, residing and domiciled at Rivière-du-Loup vs OMER LEBEL, laborer, of Ri-vièrc-dii-Loup.A lot of land situated on the South side of Bellevue Street, in the city of Rivière-du-Loup, measuring fifty feet in width East-west, by approximately one hundred and ten feet in depth North-South, English measure, as bounded in front, on the northwest by Bellevue Street; on the southeast, by the land of Albert Beaulieu, on the northeast, by the land of J.-Baptiste Marchand, and on the southwest, by the residue of the land of the lady vendor, which lot of land thus described and bounded, is a part of the lot land known and designated under number 2720 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 Fraserville, comté de Témiscouata, circonstances et dépendances.Le tout pour être vendus à la porte de l'église de St-Patrice, de Rivière-du-Loup, MARDI le QUATORZIÈME jour de JUILLET 1959 (quatorzième jour de juillet 1959) à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif du Bureau du Shérif, district de Kamouraska, Rivière-du-Loup, CYRILLE PELLETIER, ce 30 mai 1959.50738-23-2-o [Première insertion: samedi le G juin 1959.] Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Quéhec District de Kamouraska Cour de Magistrat, / p A MILLE MOREAU, N° 10744.< ^\u2014À commerçant de clie-l vaux, résidant et domicilié à Notre-Dame du Lac, demandeur; vs JOSEPH BLANCHETTE, domicilié à Pied du Lac, comté de Témiscouata, défendeur.Le lot numéro B du rang XII.canton de Cahano, à l'endroit appelé \"Pied du Lac\", borné au nord-est au lot de terre numéro A, au sud-est au numéro 1 des lots renversés, au sud-ouest au numéro C, et au nord-ouest partie du Lac Long, le tout avec bâtisses susconstruites, circonstances et dépendances.Le tout pour être vendus à la porte de l'église de Pied d» Lac, LUNDI, le TREIZIÈME jour de JUILLET 1959, à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif du Bureau du Shérif, district de Kamouraska, Rivière-du-Loup, CYRILLE PELLETIER.ce 30 mai 1959.50739-23-2-o [Première insertion: samedi le 6 juin 1959] MÉGANTIC Fieri Facias de Terris Cour de Magistrat.( T E.FERLAND LTÉE.N° 1074.J \u2022 de la cité de Thetford ' Mines, comté de Mégantic.dans le district de Mégantic, demanderesse, contre YITALINE CHABOT, de la cité de Thetford Mines comté de Mégantic.dans le district de Mégantic, défenderesse.Désignation: \"Un morceau de terrain situé en la cité de Thetford Mines, connu et désigné comme étant le lot numéro dix-huit, de la subdivision du lot numéro vingt-cinq-F (N° 25-F-1S) du cadastre officiel pour le quatrième rang du canton de Thetford\".Pour être vendu à Thetford Mines, le TRENTIÈME jour de JUILLET mil neuf cent cinquante-neuf à DEUX heures «le l'après-midi, à la porte de l'église de la paroisse Notre-Dame «le la Présentation.Le Shérif, Bureau «lu Shérif.ALBERT LAMONDE.Thetford Mines, le 19 juin 1959.50877-24-2-o MONTMAGNY Fieri Facias de Terris ( 'aliada \u2014 Province «le Québec District de Montmagny Cour Supérieure.(\\ /TAU RICE ROUS-District «le Québec.) S E A U & C I E N° 91-873.\\ LTÉE, corporation légale \\ avant son siège social à Québec, demanderesse; vs ROMÉO HARBOUR de Armagh, défendeur.one hundred and twenty (120) on the official cadaster for the town of Fraserville, county of Témiscouata, circumstances and dependencies.The whole to be sold at church AGRICOLE DU QUÊ-\\ BEC, corps politique et in-corporé, ayant son siège social à Québec, demanderesse; vs ADÊODAT PELLETIER, cultivateur, domicilié à Stc-Irène, comté de Mata-pédia, district de Rimouski, défendeur.Une terre située dans la paroisse de Ste-Irène, comté de Matapédia, ayant une superficie de deux cent douze (212) acres et deux dixième (2/10) d'acre, étant les lots connus et désignés sous les numéros dix et onze du cadastre officiel du rang trois (3) du canton Neintayé, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendue \"en bloc\" à la porte de l'église de la paroisse de Ste-Irène, le DIXIÈME jour de JUILLET, 1959, à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, JACQUES MARTIN.Rimouski, 1er juin 1959.50742-23-2-o ROBERVAL Fieri Farias Canada \u2014 Province de Québec District de Roherval Com- Supérieure, ( XTE M R O D GILB E R T, N° 22,444.< journalier de Ste-Anas- tasie, demandeur, vs J.-EUGÈNE LAROUCHE, voiturier de Notre-Dame de Lorettc, comté de Roherval, défendeur.\"Un terrain emplacement situé à Notre-Dame de Lorettc, mesurant 100 pieds de front ou largeur par 100 pieds de profondeur, mesure anglaise, faisant partie du lot numéro A-2 (ptie A-2) du Bloc A, du cadastre officiel du canton Antoine; ledit terrain borné en front à l'est au chemin public ou rue principale; au sud au terrain de William Dufour; en profondeur à l'ouest au résidu dudit lot ou terrain de la Fabrique de Notre-Dame de Lorettc et au nord à la rue du cimetière; avec les bâtisses dessus construites appartenances et dépendances.\" Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Notre-Dame de Lorette, comté de Roherval, le NEUVIÈME jour de JUILLET 1959, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif du district de Roherval, LÉON-MAURICE LA VOIE.Bureau du Shérif, Palais de Justice, District de Roberval, le 2 juin 1959.50758-23-2-o [Première insertion: le G juin 1959) Fieri Farias Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure.i T> A Y MON D BOUCHARD, N° 22.331.i ^ YVON BOUCHARD et l CONRAD BOUCHARD, fai-sant affaires ensemble sous le nom de \"Raymond Bouchard & Frères Enrg.\", comme marchands généraux à St-François de Sales, demandeurs vs Mme Vve HENRI LA VOIE, de St-François de Sales, défenderesse.AVIS DE VENTE \"A titre de possesseur: Anima Domini\" Ix)t numéro 0.rang 0, canton de Charlevoix; lot numéro 11, fang 0, canton de Charlevoix; lot Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski Superior Court, / «TE QUEBEC FARM CRE-No.22,000.< 1.DIT BUREAU, body 1 politic and corporate, having its head office in Quebec, plaintiff; vs ADÊODAT PELLETIER, farmer, domiciled at Ste.Irène, county of Matapédia district of Rimouski, defendant.A farm situate in the parish of Ste.Irène, county of Matapédia, having an area of two hundred and twelve (212) acres and two tenths (2/10) of an acre, being lots known ami designated under numbers ten and eleven of the official cadastrer of range three (3) of the township of Nemtaye, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold \"en bloc\" at the door of the church of the parish of Ste.Irène, the TENTH day of JULY 1959, at TWO o'clock in the afternoon.JACQUES MARTIN, Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Rimouski, June 1st, 1959.50742-23-2 ROBERVAL Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, I XTE M ROD GIL B E RT, No.22,444.\\ laborer of Stc-Anasta- Isie, plaintiff, vs J.-EUGÈNE LAROUCHE, carrier, of Notre-Dame de Lorette, county of Roherval, defendant.\"An emplacement lot situated at Notre-Dame de Lorette, measuring 100 feet in frontage or in width by 100 feet in depth, English measure, forming part of lot number A-2 (pt.A-2) of Block A, of the official cadaster of the township Antoine; the said lot bounded in front on the east by the public road or principal street; on the south, by the land of William Dufour; in depth, on the west, by the residue of the said lot or land of the church property (Fabrique) of Notre-Dame de Lorette and on the north, by the street of the cemetery; with the buildings thereon erected appurtenances and dependencies.\" To be sold at the church door of the parish of Notre-Dame de Lorette, county of Roberval, on the NINTH day of JULY, 1959, at TWO o'clock in the afternoon.LÉON-MAURICE LA VOIE, Sheriff for the district of Roberval.Sheriff's Office, Court House, District of Roberval, June 2, 1959.50758-23-2 [First insertion: June 6, 1959] Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, I T> AYMOND BOUCHARD, No.22.331.{ YVON BOUCHARD and 1 CONRAD BOUCHARD, carrying on business together under the name of \"Raymond Bouchard & Frères Enrg.\", as general merchants at St.François de Sales, plaintiffs vs Mrs.HENRI LA VOIE, widow, of St.François de Sales, defendant.NOTICE OF SALE \"As possessor: Animo Domini\" Lot number 6, range 6, township of Charlevoix; lot number 11, range 0, township of Char- QUEHEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2725 numéro 19, rang 7, canton de Charlevoix; et la moitié ouest du lot numéro 9, rang 7, canton de Charlevoix, en la possession \"Amino Domini\" de la défenderesse, Dame Vve Henri Lavoie, avec bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Saint-François de Sales, comté de Roberval, le TRENTIÈME (30) jour de JUILLET 1959, à DEUX heures de l'après-midi.1a: Shérif du district de Roherval, L ÉON -» IA URICE LA VOIE.Bureau du Shérif, Palais de Justice, District de Roherval, le 19 juin 1959.50879-26-2-o [Première insertion: samedi le 27 juin 1959.] SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris Province de Québec District de St-FrjUtçois Cour de Magistrat, t TJTÔTEL-DIEU D E N° 54837.\\ H SIIE R B R O O K E, '\u2022corporation civile légalement constituée, ayant son siège social en la cité de Sherbrooke, district de St-François, demanderesse, vs DENIS DODIER.de Paquctteville, district de Saint-François, défendeur.\"Un certain morceau de terre, situé dans le canton Hereford, connu et désigné comme étant le lot N° 12-J (12-J), dans le rang-A (R-A).sur le plan officiel et dans le livre de renvoi dudit canton, contenant un tiers d'acre en superficie.Avec les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Venant de Hereford (Paquettevillc), MERCREDI, le VINGT-NEUVIÈME jour de JUILLET 1959, à DIX heures a.m.Le Shérif, Bureau du Shérif, JOSEPH LABRECQUE.Sherbrooke, ce 22 juin 1959.50907-26-2-o [Première insertion: le 27 juin 1959.] levoix; lot number 19, range 7, township of Charlevoix; and the west of half of lot number 9.range 7, township of Charlevoix in possession \"Animo Domini\" of the defendant, Airs.Henri Lavoie, widow, with buildings thereon erected appurtenances and dependencies.^ To be sold at the parochial church door of ¦St.François de Sales, countv of Roberval, on the THIRTIETH (30) day of JULY, 1959, at TWO o'clock in the afternoon.LEON-MAURICE LAVOIE, Sheriff of the district of Roherval.Sheriff's Office, ( 'iilirl House, District of Roberval, June 19, 1959.50S79-2G-2 [First insertion: Saturday, June 27, 1959.] SAINT FRANCIS Fieri Facias de Bonis et de Terris Province of Quebec District of St.Francis Magistrate's ( 'ourt, ( T-JÔ T E L - DIE U D E No.51837.\\ \\ \\ S II E RBROOKE, ^ civil corporation legally constituted, having its corporate seat in the city of Sherbrooke, district of St.Francis, plaintiff, vs DENIS DODIER, of Paquctteville, district of St.Francis, defendant.\"A certain piece of land, situate in the township Hereford, known and designated as being lot No.12-J (12-J) in rangc-A (R.A) upon the official plan and in the book of reference of said township, containing one third of an acre in superficies.With buildings thereon erected, circumstances and dependences.To be sold at the door of the parochial church of St-Vcnant of Hereford ('Paquctteville) WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH day of JULY, 1959 at TEN o'clock in the forenoon.JOSEPH LABRECQUE, Sheriff's Office.Sheriff.Sherbrooke, June the 22nd, 1959.50907-2G-2-o [First insertion: June the 27th, 1959.] TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure, I JACQUES BEAUDOIN, de-MontréaJ, \\J mandeur, vs RÉGIS N° 466039.v QUINCOU, défendeur.AVIS DE VENTE La partie du lot 104 subdivision 51 de la paroisse de St-Eustache, \"district de Terrebonne, avec toutes les bâtisses qui peut y avoir dessus construites.Pour être vendu à la porte de l'église Ste-Marthcsurle Lac.paroisse de St-Eustache, MERCREDI, le VINGT-NEUVIÈME jour de JUILLET 1959 à UNE heure de l'après-midi (29 juillet 1959 à 1 lire p.m.).Conditions de vente: Argent comptant.Ia> Shérif, Bureau du Shérif, ( iEO.AU(XAIR.St-Jérômc, 19 juin 1959.60880-26-2-o Canada \u2014 Province de Quebec District de Terrebonne Cour Supérieure, fpAGÉ & FRÈRE LTÉE.Montréal, ) un corps politique et cor-N° 468576.] poratif, dûment constituée en (corporation, et ayant son TERREBONNE Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, f JACQUES BEAUDOIN , Montreal,' \\J plaintiff vs RÉGIS QUIN-No.4GG039.v COU, Defendant.NOTICE OF SALE Part of lot 101, subdivision 51 of the parish of St.Eustachc, district of Terrebonne, with all buildings that may be erected thereon.To be sold at the church door of Ste Marthe sur le Lac, parish of St.Eustachc, WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH day of JULY, 1959, at ONE o'clock in the afternoon (July 29, 1959, at 1.o'clock p.m.).Condition of Sale: Cash.GEO.AUCLAIR, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, June 19, 1959.50880-20-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, (pÀGÉ & FRÈRE LTÉE, Montreal.) *- a body politic and corp-No.468576.) orate, duly incorporated, hav-' ing its head office and priuci- 2726 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 siège social et principale place d'affaires en la ville de Laval-Ouest, district de Terrelionne.demandeurs vs LUCIEN PARENT, de la cité d'Outremont, district de .Montréal, défendeur.AVIS DE VENTE Un emplacement situé en la cité de St-Eusta-chc, connu et désigné tel que mentionné et composé de; 1° Le lot N° 7 de la subdivision du lot originaire N° 145 (145-7) aux plan et livre de renvoi officiels du village de St-Eustache; «) Le lot N° 2 de la subdivision du lot originaire N° 180 (180-2) aux plan et livre de renvoi officiels.Avec les constructions dessus érigées portant le numéro civique 150 rue St-Viateur.\".Pour être vendu à la porte de l'église de Sl-Eustache, MERCREDI, le YTNGT-NElMÊME jour de JUILLET 1050 à TROIS heures de l'après-midi.(20 juillet 1050.3 lires* p.m.).Conditions vente: argent comptant.Le Shérif.Bureau du Shérif, GEO.AUCLATR.St-Jérôme, 10 juin 1059.50881-30-2 TROIS-RIVIÈRES Canada, \u2014 Province de Québec District de Trois-Rivières Cour Supérieure, (TA CIE DE BOIS ST-N° 18891.< *-» LAURENT LTÉE, cor-l poration légalement constituée ayant son siège social au Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, est, demanderesse, vs EDDY PARADIS, du Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, est, défendeur, & RODRIGUE BAILLY, de Chaniplain, district de Trois-Rivières, en sa qualité de Régistrateur pour la division d'enregistrement pour le comté de Chaniplain, est mise-en-cause, ladite \"La Cie de Bois St-Laurent Ltée\", demanderesse, ledit Eddy Paradis, défendeur.\"Une certaine étendue de terrain située dans la paroisse du Cap de la Madeleine, de figure irrégulière et comprise dans les bornes suivantes: en front, vers le sud-est, le chemin public, en profondeur, vers le nord-ouest, le ruisseau de la Mine, d'un côté, vers le nord-est, le lot numéro cinq cent quatre-vingt-deux (No.582) appartenant à M.Gagné et de l'autre côté, vers le sud-ouest, la.route qui conduit dudit chemin au ruisseau de la Mine, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances.A distraire cependant les parties vendues par Eddy Paradis.Cette étendue de terrain est maintenant connue et désignée comme étant: o) Une partie non subdivisée du lot numéro cinq cent soixante-dix-neuf (Ptie No.579) des plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Cap de la Madeleine; 6) Les lots numéros un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit, neuf, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-deux, vingt-cinq et vingt-huit de la subdivision officielle dudit lot numéro cinq cent soixante-dix-neuf (Nos.579-1, 2, 3, 4, 5, G, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 25 et 28) dudit cadastre officiel du Cap de la Madeleine.\" Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse Stc-Marie Madeleine du Cap-de-la-Madeleine, MERCREDI, le HUITTEME jour du mois de JUILLET, mil neuf cent cinquante-neuf, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, L.P.MERCIER.Trois-Rivières, le 30 mai 1959.50740-23-2-u 4>al place of business in the town of Laval West» district of Terrebonne, plaintiff vs LUCIEN PARENT, of the city of Outremont, district of Montreal, defendant.NOTICE OF SALE ^ An emplacement situated in the city of St.Eustachc, known and designated as and composed of; 1.Lot No.7 of the subdivision of original lot No.1 15 (145-7) on the officia] plan and book of reference of the village of St.Eustachc; 2.Lot No.2 of the subsivision of original lot No.ISO (180-2) on the said official plan and book of reference.With building thereon erected bearing civic No.150 St-Viateur Street.\" To be sold at the church door of St.Eustachc, WEDNESDAY, the TWENTY-NINTH day of JULY, 1959 at THREE o'clock in the afternoon.(July 29,1959, 3 o'clock p.m.).Condition of Sale: Cash.GEO.AUCLAIR, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, June 19, 1959.50S81-20-2 TROIS-RIVIÈRES Canada \u2014 Province of Quebec District of Trois-Rivières Superior Court, i T A CIE DE BOIS ST-No.18891.< -L* LAURENT LTÉE, cor-(.poration legally constituted having its head office at Cap-de-la-Madeleine, district of Trois-Rivières, is plaintiff vs EDDY PARADIS, of Cap-de-la-Madeleine, district of Trois-Rivières, defendant, & RODRIGUE BAILLY, of Chaniplain, district of Trois-Rivières, in his capacity of Registrar for the registry division of the county of Chaniplain, mis-cn-cause, the said La Cie de Bois St-Laurent Ltée, plaintiff, the said Eddy Paradis, defendant.\"A certain area of land situated in the parish of Cap-de-la-Madeleine, of irregular shape and included within the following boundaries: in front, southeasterly, the public highway, in depth, northwesterly, the Mine Brook, on one side, northeasterly, lot number five hundred and eighty-two (No.582) belonging to M.Gagné and on the other side, southwesterly, the road leading from the said road to the Mine Brook, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be excluded however, those parts sold by Eddy Paradis.This area of land is now inown and designated as being: a) A non-subdivided part of lot number five hundred and seventy-nine (P.No.579) of the official plan and book of reference of the cadaster of Cap de la Madeleine; b) Lot numbers one, two, three, four, five, six, eight, nine, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-two, twenty-five and twenty-eight of the official subdivision of said lot number five hundred and seventy-nine (Nos.579-1, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 25 and 2S) of the said official cadaster of Cap de la Madeleine.\" To be sold at the door of the Church of the parish of St.Marie Madeleine du Cap-de-la-Madeleine, WEDNESDAY, the EIGHTH day of the month of JULY, one thousand nine hundred and fifty-nine, at TEN o'clock in the forenoon.L.P.MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.Trois-Rivières, May 30, 1959.50740-23-2 QUEBEC OFFICLI /, GAZETTE, Quebec, June 21th, 1959, Vol.91, No.26 2727 Index de la Gazette officielle Index of the Quebec Official de Québec, N° 26 - Gazette, No.26 Arrêtés en Conseil: Oudkks in (nuxni,: 614-A \u2014 Employés de Garage, Ile de 614-A \u2014 Garage employees, Island of Montréal.2091 Montreal.2091 614-B \u2014 Const ruction, region de Jo- 614-13 \u2014 Construction, region of Joliette.2691 licite.2691 614-C \u2014 Construction, region de Mont- 614-C \u2014 Construction, region of Montreal.2695 real.2695 Avis aux intéressés: 2645 Notice to Interested Parties: 2645 Avis divers: Miscellaneous Notices: Agence de Voyages Dufour, Inc.\u2014 Dufour Travel Agency, Inc.\u2014 Agences Dufour Travel Agency, Inc.(Dircc- de Voyages Dufour, Inc.(Directeurs).2702 tors).*.2702 Autobus Lévis-Québec Inc.(Nom Autobus Lévis-Québec Inc.(Name changé).2702 changed).2702 Bibis Yukon Mines Limited (N'ente Bibis Yukon Mines Limited (Sale of d'actions).2701 shares).2701 Fashion Clove Incorporated (Dircc- Fashion Glove Incorporated (Directeurs).2702 tors).2702 L'Association des Entrepreneurs du Dis- L'Association des Eut repreneurs du Dis- trict de Hull et de l'Ouest du Québec trict de Hull et de l'Ouest du Québec (Nom changé).2703 (Name changed).2703 Morgan & Co.Ltd (Directeurs).2701 Morgan & Co.Ltd (Directors).2701 Mountain Realties Limited (Dist.de Mountain Realties Limited (Dist.of l'actif).2703 assets).2703 Quebec Cobalt and Exploration Limited Quebec Cobalt and Exploration Limited (Directeurs).2703 (Directors).2703 Régie de l'Électricité et du Gaz (Gaz Electricity and Gas Board (Cas and et Sécurité publique).2701 Public Safety).2701 St-IIcnri-dc-Taillon.paroisse (Tirage St-Henri-dc-Taillon, parish (Drawing d'obligations).2703 of bonds).2703 Chartes \u2014 Abandon de: ( Iharters \u2014 Surren der of: Albert Robert Limitée.2704 Albert Robert Limitée.2701 Pccl Building Corporation.2704 Peel Building Corporation.2704 Solid Clove Limited.2704 Solid Glove Limited.2704 Suburban Enterprises lue.2705 Suburban Enterprises Inc.2705 The Sherbrooke Apartments Limited.2704 The Sherbrooke Apartments Limited.< 2704 Compagnie autorisée à faire des Company Licensed to do Business: affaires: C.W.Fuelling.Inc.2705 C.W.Fuelling, Inc.2705 DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: ' DEPARTMENTAL NOTICES: Affaires Municipales: Municipal Affairs: \u2022Pointe-Gatineau (Érection).2705 Pointe-Gatineau (Erection).2705 Instruction publique: Education: .1/ ii n icipâlité \"cola Ire de: School M un ici pal il y of: Berthier, ville.-'70s Berthier, town.2708 Lac-Bouchctte, cath.2708 Lac-Bouchelte, cath.£W Lac-Labelle.2708 Lac-Labelle.2708 Nominingiie., \u2022 2707 Nomnunguc.^JJ' Notre-Dame-du-Nord.2707 Notre-Dame-du-Nord.2/07 Pascalis.2707 Pascalis.*M Pcrron .2707 Perron.2/0/ Ste-Thérèse, cath.270S Ste-Thérèse.cath.2/08 St-JeaR-L'Êvangéliste.2708 St-Jean-L Evangéhste.^'98 Travail: Labour: Industrie ou métiers de Industry or Trades of: Barbier, coiffeur et coiffeuse, district de Barber and hairdresser, district of St.Samt-François'(Modi(ication).2095 Francis (Amendment).^hJo 2728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 27 juin 1969, Tome 91, N° 26 Commerce, régiondu Lac St-Jean (Pré- Commerce, région du Lac St-Jean lèvcmcnt).2099 (Levy).2099 Meuble de Québec (Prélèvement).2090 Furniture of Quebec (Levy).2000 Peinture (Prélèvement).2098 Paint (Levy).2098 Lettres patentes: Letters Patent: ABC Builders Supply' Ltd.2010 Algol Realty Limited.2017 Ambulance Métropole Ltée.20-17 Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited.2017 Atlantic Felt Inc.r:.20IS Avion Construction Co.Inc.2048 Bareli Realty Company.20-18 Bastogne Investment Corp.2049 Beloff Brothers Flooring &Tile Limited 2649 Better Building Construction Ltd.2649 Better Living Apartments Inc.2650 Bijouterie John Nagy Ltée.2050 Biron & Poirier Inc.2050 Blondin Automobiles Limitée.2051 Breuvage G.et M.Limitée \u2014 G.and M.Soft Drinks Limited.2051 Castle Investment Corporation.2051 Centre de Loisirs de Ste-Agathe des Monts Inc.2052 Champlain Propane Cas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Propane Champlain.2052 Charles Alarie Ltée.2052 Conrad Heating Company.2053 D.C.L.Construction Ltée.2053 Denelco Investment Corp.2053 Dorchester Woollens Ltd.2054 Elliott Investments Inc.2054 Esco Realties Inc.2054 Franklin Woodwork Inc.,.2055 Gagnon Frères \"Exécutif\" Ltée.2055 Garage International Sept lies Inc.2055 Gepner Realties Inc.2050 Ger-Vin Construction Inc.2050 Gibraltar Excavation & Construction Co.Ltd.2050 Glenguard Investment Corp.2057 Golfe Oxygène Ltée \u2014 (Gulf Oxygène Ltd.).2657 Grandview Realties Ltd.2657 Grynspan Caplan Construction Co.Ltd.2658 Hôtel Cartier Inc.2658 Hôpital du Sacré-Cœur de Hull.2709 Industrial Business, Forms Ltd.2058 Irving Sales Corp.2059 ' Jalore Limitée.2059 J.R.Séguin Limitée.2059 Kent Street Development Corp.2000 L'Abord-à-Plouffe Community Association.2000 Lafond & Bergeron Cie Ltée.2000 Lampron & Fils Ltée.2001 La Salle Gardens Inc.2001 L'Association des Propriétaires du Nord de Montréal \u2014 North End of Montreal Home Owners Association.2001 Le Club de Golfe de Berthier Inc.\u2014 The Berthier Golf and Country Club Inc.2002 Le Meuble de Distinction Inc.2002 Leopold Emard Ltée.2003 Les Bétons Préparés Universels Ltée .2003 Les Entreprises de Beauce Inc.2003 Les Habitations St-Sulpice Inc.2004 Les Immeubles Lebon Limitée.2004 Les Immeubles Monpré Limitée.2004 Les Loisirs du Coeur Immaculée de Marie Ste-Thérèse Inc.2005 Les Placements Nemo Inc.2005 Les Transports ABC.Limitée.2005 A B C Builders Supply' Ltd.2040 Algol Realty Limited.20-17 Ambulance Métropole Ltée.2047 Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited____.2647 Atlantic Felt Inc.2648 Avion Construction Co.Inc.2648 Bareli Realty Company.2648 Rastognc Investment Corp.26-10 Beloff Brothers Flooring & Tile Limited 2040 Better Building Construction Ltd.2040 Better Living Apartments Inc.2050 Bijouterie John Nagy Ltée.2050 Biron & Poirier Inc.2650 Blondin Automobiles Limitée.2651 G.and M.Soft Drinks Limited \u2014 Breuvage G.et M.Limitée.2651 Castle Investment Corporation.2651 Centre de Loisirs de Ste-Agathe des Monts Inc.2652 Champlain Propane Gas Corporation \u2014 La Corporation de Gaz Propane Champlain.2652 Charles Alarie Ltée.2652 Conrad Heating Company.2653 D.C.L.Construction Ltée.2653 Denelco Investment Corp.2653- Dorchester Woollens Ltd.2654 Elliott Investments Inc.2654 Esco Realties Inc.2654 , Franklin Woodwork Inc.2655 Gagnon Frères \"Exécutif\" Ltée.2655 Garage International Sept lies Inc.2655 Gepner Realties Inc.2656 Ger-Vin Construction Inc.2656 Gibraltar Excavation & Construction Co.Ltd.2656 Glenguard Investment Corp.2657 Golfe Oxygène Ltée \u2014 (Gulf Oxygène Ltd.).2657 Grandview Realties Ltd.2657 Grynspan Caplan Construction Co.Ltd.2658 Hôtel Cartier Inc.2658 Hôpital du Sacré.-Cœur de Hull.2709 Industrial Business Forms Ltd.2058 Irving Sales Corp.2059 Jalore Limitée.2059 J.R.Séguin Limitée.2059 Kent Street Development Corp.2000 L'Abord-à-Ploufle Community Association.2000 Lafond & Bergeron Cie Ltée.2000 Lampron & Fils Ltée.2001 La Salle Gardens Inc.2001 North End of Montreal Home Owners Association \u2014 L'Association des Propriétaires du Nord de Montréal.2061 The Berthier Golf and Country Club Inc \u2014Te Club de Golfe de Berthier Inc.2662 Le Meuble de Distinction Inc.2002 Leopold Êmard Ltée.2603 Les Bétons Préparés Universels Ltée .2003 Les Entreprises de Beauce Inc.2063 Les Habitations St-Sulpice Inc.2664 Les Immeubles Lebon Limitée.2664 Les Immeubles Monpré Limitée.2664 Les Loisirs du Coeur Immaculée de Marie Ste-Thérèse Inc.2665 Les Placements Nemo Inc.2605 Les Transports ABC.Limitée .;- 2665 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol 91, No.26 2729 Lionel Arsenault Inc.2G0G Marian Investment Corp.2G66 Marlene Mines Ltd.2006 Marshall Bros.Inc.2667 Metro Chesterfield Ltd.2667 Mikron Realties Corp.2667 Milton Kanter Ltd.2668 Modan Taxi Ltd.2668 Moon Valley Lumber Ltd.2668 Momininguc Transport Ltée.2669 Norbloc Ltée.2669 Norman Specialties Inc.2669 N.R.W.Enterprises Ltd.2670 Omega Motors Ltd.2070 Omcr Borret & Cie Ltée.2070 Paris Star Inc.2071 Perrée & Caron (Meubles) Ltée \u2014 Perrée & Caron (Furniture) Ltd.2071 Pindor Investment Corporation.2072 Plomberie André Côté Ltée.2072 President Development Corp.2072 Quebec Epilepsy League, Inc.2673 Raymond Hardware Inc.2673 Ray's Service Station Ltd.2073 Rideau Metals & Equipment Ltd.207-i Rima Ltd.2071 Rioux & Frères Inc.2071 R.Laflamme & Frère Inc.2075 Robert Frenette Inc.2075 Rosemount Welding Contractors Ltd.2075 R.Trottier Ltée.2070 Sandra Land Development Corp.2070 Seven Pillars Investment Corp.2070 Stafford Development Ltd.2077 St.Clair Products & Equipment Ltd.2077 Suburban Land Sale Corp.2077 Tafler Insurance Agency Inc.2078 The Family Welfare Association of Montreal .2078 Tvrone Mines Limited-.2070 Warren-Gold Co.Ltd.2079 Weldon International Corporation .2080 Western Tire & Auto Supply (Quebec) Limited.2080 Yvon Dupuis Musique Ltée.2080 Yvon Giguère Inc.2081 Zurich Investment Corp.26SI Lettres Patentes supplémentaires: Alouette Canadian Soccer Club Inc.26S1 Association Sportive d'Ibervillé, Inc.2082 Bijouterie Pierre Jewellery Company .2682 Cable T.V.Ltd.2682 Canado Clima Inc.2682 Carbec Mines Limited.2683 Carrière Gouin Limitée \u2014 Gouin Quarry Limited.2683 Cog Co.2683 Continental Store (Campbellton) Ltd.\u2014 Magasin Continental (Campbellton) Ltée.2683 Consolidated Plywood Corporation.2684 Eiram Limitée.2084 Fairlanc Development Inc.2084 Gauthier Meubles Ltée.2084 Gillroy Construction Limited.2685 Inter-Cité Transport Limitée \u2014 Inter-City Transport Limited.2685 Lachine Super Market Inc.2685 Laird Rcaltv Corp.2685 \"L.D.& H.Schreiber Ltd.2686 LeChasseur Inc.2080 Lefebvre Automobiles Ltée.2686 Les Entreprises de l'Est Ltée \u2014 Eastern Enterprises Ltd.2080 Les Frères Brisson Inc.L'Hoir Inc.2087 Lionel Arsenault Inc.2666 Marjan Investment Corp.2000 Marlene Mines Ltd.2006 Marshall Bros.Inc.2667 Metro Chesterfield Ltd.2667 Mikron Realties Corp.2667 Milton Kanter Ltd.2268 Modan Taxi Ltd.2668 Moon Valley Lumber Ltd.2668 Mominingue Transport Ltée.2669 Norbloc Ltée.2669 Norman Specialties Inc.2669 N.R.W.Enterprises Ltd.2670 Omega Motors Ltd.2070 Orner Borret & Cie Ltée.2070 Paris Star Inc.2071 Perrée & Caron (Furniture) Ltd.\u2014 Perrée & Caron (Meubles) Ltée.2071 Pindor Investment Corporation.2072 Plomberie André Côté Ltée.2072 President Development Corp.2072 Quebec Epilepsy League, Inc.2073 Raymond Hardware Inc.2073 Ray's Service Station Ltd.2073 Rideau Metals & Equipment Ltd.2674 Rima Ltd.2674 Rioux & Frères Inc.2674 R.Laflamme & Frère Inc.2675 Robert Frenette Inc.2675 Rosemount Welding Contractors Ltd.2675 R.Trottier Ltée.2676 Sandra Land Development Corp.2676 Seven Pillars Investment Corp.2676 Stafford Development Ltd.2077 St.Clair Products & Equipment Ltd.2077 Suburban Land Sale Corp.2077 Tafler Insurance Agency Inc.2078 The Family Welfare Association of Montreal .2678 Tyrone Mines Limited.2079 Warren-Gold Co.Ltd.2079 Weldon International Corporation .2080 Western Tire & Auto Supply (Quebec) Limited.2080 Yvon Dupuis Musique Ltée.2080 Yvon Giguère Inc.2081 Zurich Investment Corp.2GS1 Supplementary Letters Patent: Alouette Canadian Soccer Club Inc.2681 Association Sportive d'Ibervillé, Inc.2682 Bijouterie Pierre Jewellery Company .2682 Cable T.V.Ltd.2682 Canado Clima Inc.26S2 Carbec Mines Limited.2683 Gouin Quarry Limited \u2014 Carrière Gouin Limitée.2683 Cog Co.26S3 Continental Store (Campbellton) Ltd.\u2014 Magasin Continental (Campbellton) Ltée.2683 Consolidated Plywood Corporation.- 2684, Eiram Limitée.2684 Fairlanc Development Inc.2684 Gauthier Meubles Ltée.2684 Gillroy Construction Limited.2685 Inter-City Transport Limited \u2014 Inter-Cité Transport Limitée.2685 Lachine Super Market Inc.26S5 Laird Rcaltv Corp.2685 L.D.& II.Schrcihcr Ltd.2GSG LeChasseur Inc.2686 Lefebvre Automobiles Ltée.2686 Eastern Enterprises Ltd.\u2014 Les Entreprises de l'Est Ltée .2686 Les Frères Brisson Inc.2687 L'Hoir Inc.2687 2730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 27 juin 1959, Tome 91, N° 26 Lirsh Enterprises Inc.2087 Montroy Investment Company, Limited 2087 Morissct Automobiles Inc.2087 Obie's Meat Inc.2088 Paul Guimond Limited.2088 Placements St-Régis Inc.\u2014 St-Regis Investments Inc.20S8 Portage Island (Chibougamau) Mines Limited.2088 Quebec Smelting & Refining Limited.2689 Segal Limited.2689 Sicard Inc.2080 The Dominino News Bureau Limited.2080 Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.2('90 Universal Enterprises Limited.2690 Variety Investors Incorporated.2090 Volkswagen Sales & Service Ltd.2090 Liquidation, avis de: * La Caisse Populaire de Stc-Claire de Colombourg.2709 La Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le l'eu de la paroisse St-Hubert.2709 La Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le feu de la paroisse St-Hubert.2709 Proclamation: Concernant l'application à une partie des cantons de Christie de Duchesnay, de Taschereau et à une partie de la municipalité de St-Maxime-du-Mont-Louis «les dispositions de la loi frela-tive aux titres de propriété dans la Gaspésie.2710 Sièges sociaux: Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited.2712 Canadian Hoechst.2713 Damas Investment Corp.2713 Denvin Inc.2714 Hudson Water Works Ltd.2714 Jaloré Limitée.2713 Les Immeubles des Monts Inc.2713 Marcel Gauthier Société Incorporée.271 \") Metcalfe Construction Co.Ltd.2714 Norvic Realt ies Ltd.271 ô Sardus Investments Ltd.2714 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi: BoufTard vs Bisson.271 ô Deràsp vs Claverny Gold M incs Limited 2715 Arthabaska: Chicoine vs Lauzière.2710 Dubé vs Gagné.271(5 Chicoutimi: Dubé ci al vs Morel et al.2717 Gaspé: Goupil vs Biais.2718 Lavery et al vs Bertrand.2718 Joliette: Lirsh Enterprises Inc.2087 Montroy Investment Company, Limited 2087 Morissct Automobiles Inc.2G87 Obie's Meat Inc.2088 Paul Guimond Limited.2688 St-Regis Investments Inc.\u2014 Placements St-Régis Inc.2688 Portage Island (Chibougamau) Mines Limited.2688 Quebec Smelting & Refining Limited.2689 Segal Limited.2689 Sicard lue.2689 The Dominino News Bureau Limited.2689 Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.2690 Universal Enterprises Limited.2090 Variety Investors Incorporated.2090 Volkswagen Sales & Service Ltd.2090 Winding up Notices: La Caisse Populaire de Stc-Claire de Colombourg.2709 La Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le feu de la paroisse St-Hubert.2709 La Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le feu de la paroisse St-Hubert.2709 Proclamation: Concerning the application to a part of townships of Christie of Duchesnay, of Taschereau and to a part of the municipality of St-Maximc-du-Mont-Louis of the provisions of the Act relative to the title-deeds in the ( iaspesia area.2710 Head Offices: Argenteuil Plumbing & Heating Company Limited.2712 Canadian Hoechst.2713 Damas Investment Corp.2713 Denvin Inc.2714 Hudson Water Works Ltd.2714 Jaloré Limitée.2713 Les Immeubles des Monts Inc.2713 Marcel Gauthier Société Incorporée.2715 Metcalfe Construction Co.Ltd.2714 Norvic Realties Ltd.2715 Sardus Investments Ltd.2714 SHERIFFS' SALES: Abitibi: Bouffard vs Bisson.2715 Derasp vs Claverny Gold Mines Limited 2715 Arthabaska: Chicoine vs Lauzière.2710 Dubé vs Gagné.2710 Chicoutimi: Dubé et al vs Morel et al.2717 Gaspé: Goupil vs Biais.2718 Lavery et al vs Bertrand.2718 Joliette: Vachon vs Ferland et vir 2718 Vachon vs Ferland et vir 2718 _QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 27th, 1959, Vol.91, No.26 2731 Québec:\u2014-Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer.Kamouraska: Kamouraska: Côté & Godbout Inc.vs Michaud.2719 Côté & Godbout Inc.vs Michaud.2719 Fraser vs Lcbel.2719 Fraser vs Lebel.2719 Moreau vs Blanchcttc.2720 Moreau vs Blanchcttc.2720 a li-a } antic: M kg anti c : J.E.Ferland Ltée vs Chabot.2720 J.E.Ferland Ltée vs Chabot.2720 Montmagny: Montmagny: Maurice Rousseau & Cie Ltée vs liar- Maurice Rousseau & Cie Ltée vs Harbour.2720 hour.2720 Thibault vs Bélanger.2721 Thibault vs Bélanger.2721 Quebec: Quebec: Boivin vs Lircttc.2721 Boivin vs Lirette.2721 Frenette vs Bédard.2721 Frenette vs Bédard.2721 Laquerre vs Corriveau.2722 Laqucrre vs Corriveau.2722 Richelieu: Richelieu: Léo Perreault Ltée vs Léger.2723 Léo Perreault Ltd vs Léger.2723 Rimouski: Rimouski: L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Credit Bureau vs Pelle- vs Pelletier.2724 .tier.2724 Stop Fire Ltd vs Proulx.2723 Stop Fire Ltd vs Proulx.2723 Roberval: Roberval: Gilbert vs Larouchc.2724 Gilbert vs Larouche.2724 Raymond Bouchard & Frères Enrg.Raymond Bouchard & Frères Enrg.vs Lavoie.2724 vs Lavoie.2724 Saint-François: St.Francis: Hôtel-Dieu de Sherbrooke vs Dodicr.272.5 Hôtel-Dieu de Sherbrooke vs Dodier.2725 Terrebonne : Terrebonne : Beaudoin vs Quincou.2725 Beaudoin vs Quincou.2725 Page & Frère Ltée vs Parent.2725 Page & Frère Ltée vs Parent.2725 Trois-Rivières: Trois-Rivières: Cie de Bois St-Laurent Ltée vs Paradis.2720 Cie de Bois St-Laurent Ltée vs Paradis.2720 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.