Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 15 (no 33)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1959-08-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 91, N° 33 3233 Vol.91, No.33 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 15 août 1959 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1959.Québec, le 20 juin 1959.L'Imprimeur de la Reine, 50831-25-1 l-o RÉDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur .réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans PROVINCE OF quebec Quebec, Saturday, August 15th, 1959 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1959.Quebec, June 20th, 1959.REDEMPTI PARADIS, 50831-25-H-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two officia! languages.When same transmitted in one language onlj .the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account am! before the second insertion: otherwise this last in ertion Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3234 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1959, Tome 91, N° S3 préjudice «les droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la.vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime dékvi expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de Ja Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ljgne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 2G6 lignes par page, pour les deux versions).Insertipns subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502\u2014l-52-o will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three hist days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administra» tion.8.Any demands for cancelation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents jfer 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions : $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion ; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS.Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502 \u2014 l-52-o Lettres patentes Letters patent (P.G.12325-59) Addington Realty Corp.Avis est donné (pi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en coporation: Moe Ackman, de L'Abord-à-Plouffe, Sidney Cutler, de Montréal, et Irwin Gliscnnan, de Côte St-Luc, tous avocats, pour les objets suivants : Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, amélioration et construction, sous le nom de \"Addington Realty Corp.\", avec un (AG.12325-59) Addington Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: Moe Ackman, of L'Abord-à-Plouffe, Sidney Cutler, of Montreal, and Irwin Gliserman, of Côte St.Luc, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, improvement and construction company, under the name of \"Addington Realty Corp.\", with a QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1969, Vol.91, No.33 3236 capital total de $36,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de Si chacune et 3,f)00 actions privi-légii es de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.I,\" Assistant-procureur général suppléant, /il i'is P.FRENETTE.(P.O.127.72-59) Agences Lambert & Brunet Agencies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1959, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux d'Outrcmont, et Iluguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Porrot, pour les objets suivants: Agir comme courtiers et agents d'immeubles, sous le nom de \"Agences Lambert & Brunet Agencies Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions communes de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(P.G.12486-59) Allison's Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: John Howard Gomery, Charles Alexander Phelan, tons deux de Montréal, et George Anthony Allison, de ville de Mont-Royal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurants, salles de repas légers, salles de thé, café et de rafraîchissements, cafétérias, comptoirs de produits laitiers el sandwichs, sous le nom de \"Allison's Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.J.c siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai, 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12670-59) Artists and Photographers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre mai 1959, constituant en corporation: Murray Lapin, de ville de Hampstead, Alan B.Gold et Morris M.Weiner, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Agir comme artistes commerciaux et exercer le commerce de photographes et reproducteurs de gravures, sous le nom de \"Artists and Photographers Inc.\", avec un capital total de $40,000, total capital stock of 136,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12752-59) Agences Lambert & Brtmet Agencies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1959, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, manager, both of Outre-mont, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of He Perrot, for the following purposes: To act as real estate brokers and agents, under the name of \"Agences Lambert & Brunet Agencies Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Sainte Adèle, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12486-59) Allison's Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: John Howard Gomery, Charles Alexander Phelan, both of Montreal, and George Anthony Allison, of the town of Mount Royal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of restaurants, lunch-rooms, tea-rooms, coffee-rooms, refreshment-rooms, cafeterias, milk-bars and sandwich-bars, under the name of \"Allison's Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $1 each and 36,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tins first day of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12670-59) Artists and Photographers Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of May, 1959, incorporating: Murray Lapin, of the town of Hampstead, Alan B.Gold and Morris M.Weiner, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To act as artists and commercial artists and to carry on the business of photographers and reproducers of pictures, under the name of \"Artists and Photographers Inc.\", with a total 3236 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août I9Ô9, Tome 91, N° 33 divisé en 1,000 actions ordinaires et 3.000 actions privilégiées, toutes d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 147\") rue Mountain.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre mai 1959.L'Assistant -procureur général suppléant.51198 P.FRENETTE.(P.G.12851-59) Beatty Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie dé la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1959, constituant en corporation: Harry L.Aronovitch, avocat, de Côte St-Luc, Samuel (\"liait, Maxwell Sbenker.avocats, et John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie «le terrains, développement et construction, sous le nom de \"Bcatty Development Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires «le Si chacune et 30,000 actions privilégiées «le SI chacune.Ix- siège social de la compagnie sera à 1255 rue Université, suite 1612.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le treize mai 1959.L'Assistnnt-procureur général suppléant.51198 P.FRENETTE.(P.G.12133-59) Berne Investment Corp.Avis est «l«)imé qu'en vertu de la première partie de la Ix>i «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dé Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: Marlènc Lacroix, Anna Mikula, secrétaires, filles majeures, et Maynard B.(Jolt, avocat, tous «le Montréal, pour les objets suivants': Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Berne Investment Corp.\", avec un capital total «le 810,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de SI chacune et 9,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.11999-59) Besson Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize avril 1959, constituant en corporation: Adam Greenspoon, marchand, Samuel Mosko-vitch, conseil en loi de la Reine, David Litner, tous deux avocats, et Pâquerette Théorêt, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et placements en général, sous le nom de \"Besson Realties Inc.\", avec un capital total capital stock «>f $40,000, divided into l.(MH) common shares and 3,000 preferred share-.ft|| of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1475 Mountain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office «>f the Attorney General this fourth day of Mav.1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12851-59) Beatty Development Corporation Notice is hereby given that under Pari I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1959, incorporating: Harry L.Aronovitch, advocate, of Côte St.Luc, Samuel Chait, Maxwell Shcnker, advocates, and John Hamilton, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Beatty Development Corporation\", with a total capital stock of 140,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 36,000 preferred shares of SI each.The bead office of the company will !¦f Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of Mav, 1950.' P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12133-59) Berne Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April.1959, incorporating: Marlènc Lacroix, Anna Mikula secretaries,\u2022 spinsters, ami Maynard B.(Jolt, advocate, all of \"Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Berne Investment Corp.\", with a total capital stock of $10.0110, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 9,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11999-59) Besson Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: Adam Green-spoon, merchant, Samuel Moskovitch, Queen's Counsel, David Litner, both advocates, and Pâquerette Théorêt, secretary, fille majeure usant de ses droits, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and general investment company, under the name of \"Besson Realties Inc.\", with a total QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91.No.S3 3237 (|, sl'O.OOO, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le seize a\\ ril 1059.I,'Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.11680-59) Cambridge Builders Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a rte accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1959, constituant en corporation: Alan IL Cold, Mollis M.Wciner, tous deux de Montréal.Murray Lapin, de ville de Hampstead, tous trois avocats, et Shirley Muggeridge, secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Cambridge Builders Inc.\", avec un capital total de $10,000, divise en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.I.e siège social de la compagnie sera à 102 avenue Ehnslie, ville LaSalle.district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.13125-59) C.E.Blier & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ¦ té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu quatre juin 1959, constituant en corporation: Claude Marchand, avocat, de St-Laurent, Raymond de Tremblay, étudiant, de Belceil, et Monique Deslandes, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles et autres produits fabriqués en bois en tout ou en partie, «¦t faire tous travaux «le menuiserie, d'ébénisterie et autres travaux connexes, sous le nom de \"C.E.blier & Fils Inc.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en -100 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hubert, comté «le Chambly, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre ' juin 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 I».FRENETTE.(P.G.12388-59) Centre Récréatif de Granby Inc.Wis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date \u2022lu dix-neuf mai 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Roger Dumas, journalier, Kita Beauchcmin Marquis, veuve, ménagère, Guy Chassé, dessinateur, René McLean, mécani- capital stock of $20,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and 150 preferred shares of a par value of $100 each.The-head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 5119S-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11680-59) Cambrulge Builders Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1959, incorporating: Alan B.Gold, Morris M.Weiner, both of Montreal, Murray Lapin, of the town of Hampstead, all three advocates, and Shirley Muggeridge, secretary, spinster of the full age of majority, of Yertjun.for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Cambridge Builders Inc.\", with a total capital stock of $10,000, \u2022 divided into 1.000 common shares of a par value of $1 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 102 Elmslie Avenue, ville LaSalle, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day «>f March, 1959.P.FRENETTE.51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13125-59) C.E.Blier & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1959, incorporating: Claude Marchand, advocate, of St-Laurent, Raymond «le Tremblay, student, of Belceil, and Monique Deslandes, secretary, spinster, of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in furniture and in other products manufactured wholly of wood or in part, and to carry on all carpentry, cabinet, and other similar type of work, under the name of \"C.E.Blier & Fils Inc.\".with a total capital stock of $60,000, divided into 2.000 common shares of a par value «>f $10 each and into 400 preferred shares of a par value of $100 each.The bead office of the company will be at Saint-Hubert, county of Chambly.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of June.1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General., (A.G.12388-59).Centre Récréatif de Granby Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of May.1959, to incorporate as a corporation without share capital: Roger Dumas, journeyman.Rita Beauchcmin Marquis, widow, housekeeper.Guy Chassé, draftsman, René McLean, 3238 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959.Tome 91, N° S3 cien, Gertrude Nadeau McLean, ménagère, épouse commune en Itiens dudit René McLean, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, M.l'abbé Paul-Emile Arcs, prêtre-vicaire, Lucien-G.Lamoureux, comptable, dean Pintal, agronome, et .Icanninc Croteau Lamoureux, secrétaire, épouse contractuellement séparée de biens dudit Lucien-G.Lamoureux, tous de Granby, pour les objets suivants: Etablir et diriger un centre de loisirs, sous le nom de \"Centre Récréatif «le Granby Inc.\".Le montant auquel sont limités lés biens immobiliers que la corporation peut posséder est de §300,000.Le siège social de la corporation sera à Granby, district judiciaire «!«¦ Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, Ô1198-0 P.FRENETTE.mechanic, Gertrude Nadeau McLean, housewife, wife common as to property of the said René McLean, ami duly authorized by him for the purposes therein.Rev.Abbé Paul-Emile Ares, priest and vicar, Lucien-G.Lamoureux.accountant, .lean Pintal, agronomist, and Jeannine Croteau Lamoureux, secretary, wife contractually separate as to property of the said Lucicn-G.Lamoureux.all of Granby, for the following purposes: To establish and manage a recreational centre, under the name of \"Centre Récréatif «le Granby Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $.300,000.The head office of the corporation will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day t>f May, 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(P.G.I-1301-09) diagram Investments Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I/>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1959, constituant en corporation: Charles M.Mendell, administrateur, Roger Cornellier, surintendant, et Leo Lupicn, machiniste, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Chagram Investments Incorporated\", avec un capital total «le 8100.000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 9,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 107,5 rue Blcury, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-trois avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12642-59) Daniel's Leather Goods Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres patentes, en date du trente avril 1959, constituant en corporation: Harry Blank, Baruch Pollack, avocats, Albert Liddell et Rhoda Cohen, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants : Fabriquer et exercer le commerce d'articles en cuir, sous le nom de \"Daniel's Leather Goods Inc.\", avec un capital total «le 8-10,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privilégiées «le 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5119N P.FRENETTE.(P.G.12757-59) David Realty Corp.(A.G.14364-58) Chagram Investments Incorporated Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of April.1959, incorporating: Charles M.Mendell, administrator, Roger Cornellier, superintendent, and Leo Lupien, machinist, all «>f Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Chagram Investments Incorporated\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1.000 common shares of 810 each and 9,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at J075 Blcury Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12042-59) Daniel's Leather Goods Inc.Notice is hereby given that under Part I «f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1959, incorporating: Harry Blank.Baruch Pollack, advocates, Albert Liddell and Rhoda Cohen, secretaries, spinsters of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and «leal in leather gi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1959, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat, d'Outremont, Mlles Louise Bourdon et Lucille Roy, de Montréal, toutes deux secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fourrages, grains, céréales, farines et.généralement, de toutes sortes de produits alimentaires, sous le nom de \"Luzerna Inc.\", avec un capital total de $100,000.divisé en 2.500 actions communes d'une valeur au pair de $10 chacune et en 3.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $25 chacune.Ix.' siège social de la compagnie sera 975.boulevard Ste-Elisabeth, Jxiprairie, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(A.G.12847-59) Luzerna Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May.1959, incorporating: Maurice Martel, advocate, of Outreinount.the Misses Louise Bourdon and Lucille Roy.of Montreal, both secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on a business dealing in fodder, grain, cereals, flour and, generally in all kinds of food products under the name of \"Luzerna Inc.\", with a total capital stock of $100.000.divided into 2,500 common shares of a par value of $10 each and into 3.000 preferred shares of \" par value of $25 each.The head office of the company will be at 975 St.Elizabeth Boulevard.Laprairie, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.83 3245 (P.G.12634-59) Meed Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1959, constituant en corporation: Max S.Kaufman, de Westmount.Joseph Roy Hoffman et Oscar Respitz, de Montreal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Meed Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le cinq mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51198 P.FRENETTE.(A.G.12034-59) Meed Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May 1959, incorporating: Max S.Kaufman, of Westmount.Joseph Roy Hoffman and Oscar Respitz, «>f Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Meed Investments Ltd.\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 10 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of Mav.1959.P.FRENETTE» 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13040-59) Menuiserie Kvain Woodwork Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «In vingt mai 1959, constituant en corporation: Denise Corriveau, secrétaire, fille majeure, de Rouyn, Gérald Ryan, avocat, et Alfred Leclerc, comptable, tous deux de Noranda, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce du bois et de tous les produits du bois, sous le nom de \"Menuiserie Evain Woodwork Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Evain, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51198-0 P.FRENETTE.(A.G.13010-59) Menuiserie Evain Woodwork Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1959, incorporating: Denise Corriveau, secretary, spinster, of Rouyn, Gerald Ryan, advocate, and Alfred Leclerc, accountant, both of Noranda, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in lumber and in all lumber products, under the name of \"Menuiserie Evain Woodwork Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4.000 common shares of a par value of $10 each.'Hie head office of the company will be at Evain, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of Mav, 1959.P.FRENETTE.51198 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12177-59) Michel Haroon Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1959, constituant en corporation: Michel Haroon, Gaston Haroon, marchands, et \\ irginia Saad, ménagère, épouse contractuel-lenient séparée de biens dudit Michel Haroon, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Victoriaville, pour les objets suivants: Acheter, vendre, manufacturer et généralement faire le commerce de vêtements, sous le nom de \"Michel Haroon Incorporée\", avec un capital total de $60,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 450 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoria-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Piocureur général, le vingt-deux mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, P.FRENETTE.(A.G.12177-59) Michel Haroon Incorporée Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1959, incorporating: Michel Haroon, Gaston Haroon, merchants, and Virginia Saad, housewife, wife contractually separate as to property of the said Michel Haroon, and duly authorized by him for these present purposes, all of Victoriaville, for the following purposes: To purchase, sell, manufacture and to generally carry on a business dealing in clothing under the name of \"Michel Haroon Incorporée\", with a total capital stock of $60,000, divided into 150 common shares of a par value of $100 each and into 450 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1959.P.FRENE1TE, 51198 Acting Deputy Attorney General. 3246 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° SS (P.G.12811-59) Montdale Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: Irving Ilalperin, Daniel Morris, avocats, et Ernest Rasbkovan, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Montdale Realties Inc.\", avec un capital total de S 10,000, divisé en 200 actions ordinaires de 810 chacune et 800 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(A.G.12811-59) Montdale Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1959, incorporating: Irving Ilalpe-rin,- Daniel Morris, advocates, and Ernest Rashkovan, notary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Montdale Realties Inc.\", with a total capital stock of S 10,000, divided into 200 common shares of $10 each and 800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12472-59) Myeo Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1959, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross, Roll in Gallay, tous trois avocats, ét Sarah Miller, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de produits fabriqués en tout ou en partie de métal, d'aliments et préparations alimentaires et d'habits et vêtements, sous le nom de \"Myco Enterprises Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.13037-59) N.D.G.Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date vingt et un mai 1959, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert Dulube, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"N.D.G.Investments Inc.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $500.Le siège social de la compagnie sera à 1411 rue Crescent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(A.G.12472-59) Myco Enterprises Inc.Notice is hereby given that un.(;.12.517-59) Neebec Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Ix>i des compagnies de Québec, il a été ai cordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation \u2022 Milton W.Winston, notaire, Côte St-Luc, Ann Druzin, secrétaire, fille majeure, de Lon-gueuil, et Isidore J.Charness, avocat, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Neebce Investment Corp.\") avec un capital total de 810,000, divisé ,.n 1(1(1 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4 est, rue Notre-Dame, chambre 504, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5H98 P.FRENETTE.(P.G.11078-59) Nu-Val Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie- de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mars 1959, constituant en corporation: Harry Kerdman, Nathan Kerdman, fabricants, tous deux de Côte St-Luc, et Joseph Slyomovics, fourreur, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Nu-Val Construction Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mars 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12(195-59) Outremont Heights Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: Roy Fraser Elliott, avocat, de ville Mont-Royal.Mary Elizabeth Spracklin et Margot Mary Quinn, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d immeubles, sous le nom de \"Outremont Heights bld.\".avec un capital total de $40,000, divisé en 4().(K!0 actions ordinaires d'une valeur au pair de Si chacune.liC siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.I-\"Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(PC 12570-59) Quemonl Construction Ltd.Qucmont Construction Ltée (A.G.12517-59) Neebee Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April.1959, incorporating: Milton W.Winston, notary, of Côte St.Luc.Ann Dru-zin, secretary, spinster, of Longueuil, and Isidore J.Charness, advocate, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Neebce Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 4 Notre Dame Street East, Room 504, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-cighth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11678-59) Nu-Val Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of March, 1959, incorporating: Harry Kerdman, Nathan Kerdman, manufacturers, both of Côte St.Luc, and Joseph Slyomovics, furrier, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Nu-Val Construction Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 400 common shares of $10 each and 600 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth daV of March, 19o9.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12695-59) Outremont Heights Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1959, incorporating: Roy Fraser Eliiott, advocate, of the town of Mount Royal, Mary Elizabeth Spracklin and Margot Mary Quinn, secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate com-panv, under the name of \"Outremont Heights Ltd'.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of May, 1959.P FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12570-59) Qucmont Construction Ltd.Quemont Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part I[of the Quebec Companies' Act, letters patent have 3248 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959.Tome 91, A'° 38 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec dès lettres patentes, en date du trente avril 11)5!).constituant en corporation: Jean Rivard, avocat, Aline Denis, Yolande de Champlain, secrétaires, célibataires, tous trois de Québec, et Lina Lemieux, secrétaire, célibataire, de Charlesbourg, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Qucmont Construction Ltd.- Qucmont Construction Ltée\".avec un capital total de 8215,000, divisé en 7,500 actions classe \"A\" d'une valeur au pair de 81 chacune, 7,500 actions classe \"B\" d'une valeur au pair de 81 chacune et en 2.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1059.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE; been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April.1959, incorporating: Jean Rivard advocate, Aline Denis, Yolande de Champlain' secretaries, spinsters, all three of Quebec, and Lina Lemieux, secretary, spinster, of Charles-bourg, for the following purposes: To carry on the business of builders and general building contractors, under the name of \"Que-mont Construction Ltd.Qucmont Construction Ltée\", with a total capital stock of 821.\".IKK), divided into 7,500 shares class \"A\" of a par value of 81 each, 7,500 shares class \"B\" of a par value of 81 each, and 2.(MM) preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of April, 1959.P.FRENETTK.5119S Acting Deputy Attorney General.(P.G.13107-59) Raymond Delisle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1059, constituant en corporation: Raymond Delisle, distributeur, Andrée Boudreault et Denise Racine, secrétaires, célibataires, tous de Jonquière, pour les objets suivants: Exercer le commerce de l'huile brute, de l'essence, du gaz naturel et.de leurs sous-produits, sous le nom de \"Raymond Delisle Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 71.rue St-Damase, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 5110S-o P.FRENETTE.(A.G.13167-59) Raymond Delisle Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1959, incorporating: Raymond Delisle.distributor, Andrée Boudreault, and Denise Racine, secretaries, spinsters, all of Jonquière, for the following purposes: To carry on a business dealing in crude oil, gasoline, natural gas and their by-products, under the name of \"Raymond Delisle Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 71 St-Damase Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13220-59) Raymond Martin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mai 1959, constituant en corporation: Raymond Martin, entrepreneur, Louise Bernier Martin, ménagère, épouse séparée de biens dudit Raymond Martin, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Québec, et Alphéc Martin, électricien, de Sillery, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'électricien; fabriquer et installer toutes sortes d'appareils et accessoires électriques et en faire l'entretien, sous le nom de \"Raymond Martin Ltée\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $1,000.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(A.G.13220-59) Raymond Martin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of May, 1959.incorporating: Raymond Martin, contractor, Louise Bernier Martin, housewife, wife separate as to property of the said Raymond Martin, and duly authorized by him for the purposes therein set forth, both of Quebec, ami Alphéc Martin, electrician, of Sillery, for the following purposes: To carry on the business of electrician; manufacture and install all kinds of electrical apparatus and appliances and the maintenance thereof, under the name of \"Raymond Martin Ltée\".with a capital divided into 100 shares without nominal or par value, and the amount with which the company shall commence its operation.** will be 81,000.The bead office of the company will be :'t Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1959.P.FRENETTE.51198 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Viol.91, No.33 3249 (P.G.12560-69) Rièl Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu do hi première partie île la Ixii des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Ilyinan Solomon, de ville Mont-Royal, Perry Meyer, de Montréal, tous deux avocats, Morris Shuter, comptable, et Louis Fcigenbaum, avocat, tous deux de St-Laurent, pour KS objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Kiel Investment Corp.\", avec un capital total de 810.000, divisé en 100 actions ordinaires de S10 chacune et 3,900 actions privilégiées de S10 chacune.Ix siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTK.(P.G.12806-59) Hi-bon Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: John .1.Wasserman, «le Westmount, Harold S.Freeman et Irving Halperin, tous deux «le Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les .affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le ikmii de \"Rishon Investment Corp.\", avec un capital total «le $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires «le $1 chacune et 1,800 actions privilégiées «le $10 chacune.Ix' siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.I/Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTK.(A.G.12500-59) Ricl Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April.1959, incorporating: Hyman Solomon, of the town of Mount Royal.Perry Meyer, of Montreal, both advocates, Morris Shuter.accountant, and Louis Fcigenbaum, advocate, both of St.Laurent, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Ricl Investment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will lie at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney («encrai, this twenty-ninth day of April.1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12800-59) Rishon Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1959, incorporating: John J.Wasserman, of Westmount, Harold S.Freeman and Irving Halperin, both of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, development an«l construction company, under the name of \"Rishon Investment Corp.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of $1 each and 1,800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 ActLo Deputy Attorney General.(P.G.12198-59) Saleras Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959, constituant en corporation: Harry L.Aronovitch, avocat, de ville Côte St-Luc, Samuel Chait, Maxwell Shcnkcr, tous deux avocats, et John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de placements, sous le nom de \"Saleras Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4.000 actions ordinaires de $1 chacune et 30.000 actions privilégiées «le $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1255 rue Université, suite 1612, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 01198 P.FRENETTE.(A.G.12198-59) Saleras Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beaiing date the third «lay of April, 1959, incorporating: Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, Samuel Chait, Maxwell Shenker, both advocates, and John Hamilton, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To act as an investment corporation, under the name of \"Saleras Investment Corporation\", with a total capital stock of $40.000, divided into 4.000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Suite 1612, 1255 University Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General. 3250 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.15 août 1969, Tome 91, A*° S3 (P.G.12804-59) Sam\u2022 «11>»\u2022 Investment Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I*oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize; mai 1959, constituant en corporation: Samuel IL Shriar, avocat, de St-Laurent, Margaret Johnson et Mollie Schwartz, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Sanrube Investment Company\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12833-59) Seaside Realty Corp.Avjs est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1959, constituant en corporation: Moc Ackman, de L'Abord-à-Plouffe, Irwin Gliserman, de ville Côte St-Luc, et Sidney Cutler, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Seaside Realty Corp.\", avec un capital, total de $5,000, divisé en 250 actions ordinaires de $10 chacune et 250 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12374-59) Sep lia n Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: Murray Lapin, de ville de Hampstead, Alan B.Gold et Morris M.Weinêr, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et placements, sous le nom de \"Sephan Investment Corp.\", avec un capital total de 81,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à 330 ouest rue Guizot, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du .Procureur général, le vingt-deux avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.10083-59) Sherwood Catering Corporation (A.G.12804-59) Sanrube Investment Company Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1959.incorporating: Samuel II.Shriar, advocate, of St.Laurent.Margaret Johnson and Mollie Schwartz, secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on an investment business, under the name of \"Sanrube Investment Company\", with a total capital stock of 840.000.divide.! into 1,000 common shares of $10 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Gel rai, this thirteenth day of May, 1959.' P.FRENETTK.51198-o Acting Deputy Attorney General.(A.G, 12833-59) Seaside Realty Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1959, incorporating: Moc Ackman, of L'Abord-à-Plouffe, Irwin Gljserman, of the town of Côte St.Luc, and Sidney Cutler, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a realty, development and construction company, under the name of \"Seaside Realty Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 250 common shares of $10 each and 250 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of Mav, 1959.P.FRENETTE.51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12374-59) Scphan Investment Corp.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April, 1959, incorporating: Murray Lapin, of the town of Hampstead.Alan B.Gold and Morris M.Wei nor, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Scphan Investment Corp.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 330 Guizot Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10083-59) Sherwood Catering Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies de Québec, il a QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.38 3251 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Edward Arthur Goodeve, administrateur, George J.Cray, comptable, tous deux de ville Mont-Royal, Ronald M.Cutts, gérant, de Valois Gardens, J.Holdcn Hutcheson, notaire, de ville de Hampslead, et Arnaud C.Mercier, gérant, de Montréal, pour les objets suivants: Kii'reprendre et exercer aucun ou tout du commerce de fabricants, cmboutcilleurs, importateurs, exportateurs, vendeurs et distributeur- et négociants de toutes sortes d'aliments et breuvages non-toxiques et non-alcooliques, sous le nom de \"Sherwood Catering Corporation\", avec un capital total de SI 10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.It siège social de la compagnie sera à 2020 avenue de l'Union, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.i Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.11902-59) Spruccwood Developments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: John L.Libcrman, Alfred N.Segal 1, Max Teitelbaum, tous trois avocats, de Montréal, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, d'Outre-mont, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une construction en général, d'immeubles et placements, sous le nom de \"Spruccwood Developments Inc.\", avec un capital total de $10.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées «l'une valeur au pair de 810 chacune.i.e siège social de la compagnie sera à 5165 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1959.I.Assistant-procureur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12799-59) Stekal Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze mai 1959, constituant en corporation: Ralph A.Cohen, Reuben Resin, avocats, Edmund Stefani et Frederick Kalau, fabricants, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Stekal Investment Corp.\", ave* un capital total de $1,000 divisé en 1,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5149 rue Marquette, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, I19S P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Edward Arthur Goodeve, executive, George J.Gray, accountant, both of the town of Mount Royal, Ronald .VI.Cults, manager, of Valois Gardens, J.Ilolden Hutcheson, notary, of the town of Hamp-stead, and Arnaud C.Mercier, manager, of Montreal, for the following purposes: To engage in and carry on any or all of the business of manufacturers, bottlers, importers, exporters, vendors and distributors of and dealers in all kinds of food and non-intoxicating and non-alcoholic beverages, under the name of \"Sherwood Catering Corporation\", with a total capital stock of $110,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 10,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 2020 Union Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Act ing Deputy Attorney General.(A.G.11902-59) Spruccwood Developments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1959, incorporating: John L.Libcrman, Alfred N.Segall, Max Teitelbaum, all three advocates, of Montreal, and Marilyn Denny, secretary, spinster of full age of majority, of Outremont, for the following purposes: To operate as a general construction, real estate and investment company, under the name of \"Sprucewood Developments Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 5165 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12799-59) Stekal Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of May, 1959, incorporating: Ralph- A.Cohen, Reuben Resin, advocates, Edmund Stcfani and Frederick Kalau, manufacturers, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and constsuction company, under the name of \"Stekal Investment Corp.\", with a total capital stcck of 81,000, divided into 1,000 shares of 81 each.The head ollice of the company will be at 5149 Marquette Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of May, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General. 3252 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 33 (P.G.12210-59) Ste.Monique Really Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec (les lettres patentes, en date du neuf avril 1959, constituant en corporation: Seymour Machlpvitch, Morris Chaikelson, avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Ste.Monique Realty Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Iaj siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté dvi bureau du Procureur général, le neuf avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTK.(P.G.11877-59) St.Laurent Stables Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixn des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1959, constituant en corporation: Fi.Michael Rcrger, avocat, Margaret Johnston, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, tous deux de Montréal, et Donald Kujan, avocat, de ville d'Anjou, pour les objets suivants: Acheter, vendre, négocier, élever et entretenir des chevaux et les faire courir, sous le nom de \"St.Laurent Stables Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de S10 chacune et 380 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(A.G.12210-59) Ste.Monique Realty Corp.Notice is hereby given that under l'art 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of ApriJ, 1959, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, advocates, and Nicole Paternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a realty company, under the name of \"Ste.Monique Realty Corp.\", with a total capital stock of $40,000* divided into 20,000 common shares of $1 each and 20.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attornev General, this ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11877-59) St.I.uiii-i-nt Stables Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters palenl have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March, 1959, incorporating: E.Michael Rcrgcr, advocate, Margaret Johnston, secretary, fille majeure et usant de ses droits, both of Montreal, and Donald Kujan, advocate, of Ville d'Anjou, for the following purposes: To buy, sell, trade in, breed and raise Ik uses and to race them, under the name of \"St.Laurent Stables Co.\", with a total-capital stock of 810.000, divided into 200 common shares of $10 each and 380 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12750-59) Sulcma Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1959, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack et Arthur Sbul-man, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général comme courtiers d'immeubles et agents à commission, sous le nom de \"Sulema Realties Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6655 avenue Fielding, app.1, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12351-59) Sun Valley Investment Corporation (A.G.12750-59) Sulema Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1959, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack and Arthur Shulman, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on business generally as real estât»; brokers and commissions agents, under the name of \"Sulema Realties Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Apt.1, 6055 Fielding Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1959.P.FRENETTK.51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12351-59) Sun Valley Investment Corporation Notice is hereby given thaj, under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Val, 91, No.SS 3253 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1959, constituant en corpo-ration: Irwin S.Brcdie, Theodore H.Polisuk, avocats, et Sonya Schneyer, secrétaire, fille ma-jeun-, tous i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Abraham Shustcr, avocat, Nathaniel Lieb-man, notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Vicinity Development Corp.\", avçc un capital total de $10.000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 900 actions privilégiées de $10 chacune.lx\" siège soeial de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12563-59) Walter Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Quéliec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Allan Colton, fabricant.Abc Arick, agent d'immeubles, et Manuel Sachs, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Walter Investment Corp.\", avec un capital total de $10,000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.13339-59) Welding Products Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept-mai 1959, constituant en corporation: Arthur Carey Strafford Stead, avocat, de Dor val, Ethel May Peirce, Violet May Griffiths, secrétaires, filles majeures, Anthony James (A.G.12039-59) Vicinity Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April.1959, incorporating: Abraham Sinister, advocate, Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, law student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Vicinity Development Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $10 each and 900 preferred shares of $10 each, '11 le head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12503-59) Walter Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor oi the Province of QucImjc.bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Allan Colton, manufacturer.Abe Arick, realtor, and Manuel Sachs, chartered accountant, all f Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Walter Investment Corp.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-ninth dav of April, 1959.P.FRENETTK.51198-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13339-59) Welding Products Limited Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1959, incorporating: Arthur Carey Strafford Stead, advocate, of Dorval, Ethel May Peirce, Violet May Griffiths, secretaries, spinsters, Anthony James Lafleur QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August lôth, 1959, Vol.91, No.33 3255 Lalleiir et Henri-Philip Lafleur, étudiants en droit, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Vendre, annoncer, promouvoir, distribuer et introduire aucun et tous produits fabriqués, marchandises, propriétés personnelles et articles sujets de négoce ou commerce de toute sorte et nature se rapportant à ou utilisés dans la soudure, construction et métiers de travaux en métal, sous le nom de \"Welding Products Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera a 25 rue des Seigneurs.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.and Henri-Philip I^afleur, students-at-law, ail four of Montreal, for the following purposes: To sell, advertise, promote, distribute and introduce any and all manufactured products, merchandise, personal property and subjects of trade or commerce of every kind and nature related to or used in the welding, construction and metal working trades, under the name of \"Welding Products Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of a par value of $100 each.The head office of t he company will be at 25 des Seigneurs Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51198-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12333-59) Westbury Investments Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en corporation: Michael Drazner, avocat, Abc Golden, enquêteur, et Bernard Izenberg, comptable, tous de Montreal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement.s.sous le nom de \"Westbury Investments Corp.\".avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant,.51198 P.FRENETTE.(A.G.12333-59) Westbury Investments Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: Michael Dra/.ner, advocate.Abe Golden, investigator, and Rernard Izenberg, accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Westbury Investments Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1959.P.FRENETTE.51 l98-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12004-59) Westmount Gardens Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>cc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1959, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Nathaniel Liebman, notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Westmount Gardens Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.I-e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.(P.G.12594-59) Yorkdalc Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1959, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, tous d< ux avocats, de Montréal, et Gisèle LeBlanc, se- (A.G.12004-59) Westmount Gardens Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1959, incorporating: Abraham Sinister, advocate, Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, law student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"Westmount Gardens Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12594-59) Yorkdale Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1959, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, both advocates, of Montreal, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife 325G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° S3 crétaire, épouse séparée de Mous dudit Marcel LeBlanc, de St-Bruno, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Yorkdale Development Corp.\", avec un capital total de S5.000, divisé en 5.000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Manee.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 P.FRENETTE.separate as to property of Marcel LeBlanc, of St.Bruno, for the following purposes: To carry on the business of a real estate development and construction company, under the name of \"Yorkdale Development Corp.\", with a total capital stock of S5.000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The bead office of the company will be at 0720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1959.P.FRENETTE, 51198-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12014-59) 320 Ste Rose Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixn des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1959, constituant en corporation: Darby I.Strohl, administrateur, d'Outremont, David Litner, avocat, et Pâquerette Théorêt, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et placements, sous le nom de \"320 Ste Rose Limited\", avec un capital total de S 10.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de Si chacune et 900 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198 - P.FRENETTE.Lettres patentes supplémentaires (P.G.13920-59) Alliance Investment Corporation of Canada Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente juin 1959, à la compagnie \"Alliance Investment Corporation of Canada\", 1° réduisant son capital, le capital-actions annulé étant divisé en 12,975 actions sans valeur au pair; 2° fixant le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations à non moins de $501,120.Daté du bureau du Procureur général, le trente juin 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(P.G.13574-59) Ballast Iron & Metal Inc.Avis est donné «m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze juin 1959, à la compagnie \"Port Service Equipment Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du vingt-neuf janvier 1958, changeant son nom en celui de \"Ballast Iron & Fetal Inc.\".(A.G.12014-59) 320 Sic Rose Limited Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec; Companies' Act, letters patent have been- issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of April, 1959, incorporating: Darby I.Strohl, executive, of Outremont, David Lit ner, advocate, and Pâquerette Théorêt.secretary, fille majeure usant de ses droits, both of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corpora! ion, under the name of \"320 Ste Rose Limited\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1.000 common shares of $1 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1959.P.FRENETTE.5119S-0 Acting Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent (A.G.13920-59) Alliance Investment Corporation of Canada Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of June.1959, to the company \"Alliance Investment Corporation of Canada'\".1.reducing its capital stock, the cancelled capital stock being divided into 12.975 shares of no par value; 2.fixing the amount with which the said company shall continue its operations to not less than $501,120.Dated at the office of the Attorney General, thus thirtieth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13574-59) Ballast Iron & Metal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of June 1959, to the company \"Port Service Equipment Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated the twenty-ninth day of January, 1958, changing its name to that of \"Ballast Iron & Metal Inc.\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.August 15th, 1959, Vol.91, No.33 3257 Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51198-Q P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney («encrai.(P.G.13928-69) Canadian Stockholders Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ce, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente juin 1959, à la compagnie \"Canadian Stockholders Investment Corporation\", 1° réduisant son capital, le capital-actions annulé étant divisé en 0,917 actions sans valeur au pair; 2° fixant le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations à non moins de $342,935.Daté du bureau du Procureur général, le trente juin 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 I*.FRENETTE.(P.G.11944-58) Coronation Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept juin 1959, à la compagnie \"Coronation Realties Inc.\".refondant et convertissant 1,500 actions ordinaires de $10 chacune en 150 actions privilégiées de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1959.L'Assistant -procureur général suppléant.5110s-o P.FRENETTE.(P.G.13431-59) Dimensioned Veneers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du neuf juin 1959.à la compagnie \"Dimensioned Veneers Inc.\", 1) réduisant son capital de 8150.000 à 805.000.le capital-actions annulé étant divisé en 1.700 actions privilégiées de 850 chacune: 2) augmentant son capital ainsi réduit de 805.000 à 8105.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 2,000 actions \"classe A\" de 850 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1959.I .'Assist ant -procureur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(PG.ios:m-59) Eastern Milk Concentrates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux juin 1959.à la conip.tgnu.\"Eastern Milk Concentrates Ltd.\", changeant ses 500 actions ordinaires de 8100 chacune en 500 actions ordinaires sans valeur au pair, le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations étant fixé à $12,500.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1959.I- Assistant-procureur général suppléant.,|,,s ' P.FRENETTE.(A.G.13928-59) Canadian Stockholders Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of June, 1959, to the company \"Canadian Stockholders Investment Corporation\", 1° decreasing its capital stock, the cancelled share capital being divided into 0,917 shares without par value; 2.fixing the amount with which the said company shall continue its operations at not less than $342,935.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of June 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11944-58) Coronation Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the seventeenth day of June.1959, to the company \"Coronation Realties Inc.\", changing and convert ing 1,500 common shares of 810 each into 150 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June.1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13431-59) Dimensioned Veneers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the ninth day of June, 1959, to the company \"Dimensioned Veneers Inc.\", 1) reducing its capital stock from S150.000 to 805,000.the cancelled capital stock being divided into 1,700 preferred shares of $50 each; 2) increasing its capital stock thus reduced from $05,000 to $105.-000.the additional capital stock being divided into 2,000 \"class \"A\" shares of $50 each.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June.1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10834-59) Eastern Milk Concent rates Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-second day of June.1959, to the company \"Eastern Milk Concentrates Ltd.\", changing its 500 common shares of 8100 each into 500 common shares of no par value, the amount with which the said company shall continue its operations being fixed to $12,500.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of June.1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General. 3258 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 38 (P.G.13387-50) K.Leconipte Draperies Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix juin 1959, à la compagnie \"E.Leconipte Draperies Ltée\".augmentant son capital de $35,000 à 855,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de 850 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(A.G.13387-59) E.Leconipte Draperies Ltée Notice is hereby given' that under Part I 0f the Quclicc Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of June, 1959, to the company \"E.Lecompte Draperies Ltée\", increasing its capital stock from $35,000 to $55,000, the additional capital stock being divided into 400 preferred shares of $50 each.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June.1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General.f May, 1959.P.FRENETTE, 51198 Acting Deputy Attorney General. 32G0 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° S3 (P.G.13676-59) Montreal Acceptance Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux juin 1959, à la compagnie \"Montreal Acceptance Corporation\", 1) réduisant son capital, le capital-actions annulé étant divisé en 2,000 actions classe \"A\" de $40 chacune; 2) désignant les 3,500 actions classe \"IV sans valeur au pair comme 3,500 actions ordinaires sans valeur au pair; 3) augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé en 30,500 actions ordinaires sans valeur au pair, le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations étant fixé à non moins «le $200,000.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-deux juin 1059.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51198-0 P.FRENETTE.(A.G.13076-59) Montreal Acceptance Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-second day of June, 1959, to the company \"Montreal Acceptance Corporation\", 1) decreasing its capital, the cancelled share capital being divided into 2,000 shares ( !asS \"A\" of $-10 each; 2) designating the 3.500 shares class \"B\" without par value as 3,500 common shares without par value; 3) increasing its capital, the additional share capital being divided into 30,500 common shares without par value, the amount with which the company shall continue its operations being fixe«l at not less than $200,-000.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second . Sous-secrétaire de la province.51243-o RAYMOND DOUVILLE.Given at the office of the Provincial Secretary the eleventh day of August, 1959.RAYMOND DOUVILLI 51243 Assistant Secretary of the Province.Chartes \u2014 Abandon de TECHNIC© CONSTRUCTIONS INC.Prenez avis que \"Technico Constructions Inc.\" compagnie constituée sous l'empire de la Loi des compagnies de Québec, et ayant sa principale place d'affaires dans la cité de Québec, demandera au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte, suivant les dispositions de la Ix)i des compagnies de Québec.Daté à Québec, ce 17e jour de juillet 1959.Le Président de la compagnie, 51205-o RENÉ RÉLANGER.Charters \u2014 Surrender of TECHNICO CONSTRUCTIONS INC.Notice is hereby given that \"Technico Constructions Inc.\" a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Quebec, will apply t.(he Attorney General of the Province of Quebec fur leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Quebec, this 17th day of July, 159.RENÉ BÉLANGER.51205-o President of the company.LU-RICH BUILDING CORPORATION Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Lu-Rich Building Corporation\", constituée en corporation en vertu de la Ixn des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, demandera au Procureur général de la province de Québec la permisions d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de\" la I/)i des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 24e jour de juillet 1959.Le Secrétaire, 51235 PHILIP SEIGEL.SAFARI INC.Prenez avis que la compagnie \"Safari Inc.\" demandera au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Ix' Procureur de la compagnie, 51235-0 ROGER PIGEON.CITY HOUSE FURNITURE INC.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"City House Furniture Inc.\" demandera au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 15 juillet 1959.Le Procureur de \"City House Furniture Inc.\",-51237 HAROLD LANDE, C.R.LU-RICH BUILDING CORPORATION Notice is hereby given that \"Lu-Rich Building Corporation\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of (Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Date dat Montreal, this 24th day of July.1959.PHILIP SIEGEL.51235-o Secretary.SAFARI INC.Take notice that the company \"Safari Inc.\" will make an application for the surrender of its charter to the Attorney General of the Province of Quebec.ROGER PIGEON.51235-0 Attorney for the company CITY HOUSE FURNITURE INC.Notice is hereby given under the provisions of the Quebec Companies' Act that \"City House Furniture'Inc.\", will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, July 15th, 1959.HAROLD LANDE, Q.C., Solicitor for 51237-o City house Furniture Inc.CHATEAUFORT INC.Prenez avis que \"Chateaufort Inc.\" demandera au Procureur général la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 10 août 1959.Ix\\s Procureurs de la Compagnie, LANGLOIS, BISONNET DE 51238-0 GRANDPRÉ & LASNIER.CHATEAUFORT INC.Take Notice that \"Chateaufort Ine\", will apply to the Attorney General, the leave to surend* its charter.Montreal, August 10th, 1959.LANGLOIS, BISSONNET DE GRANDPRÉ & LASNIER.51238-o Attorneys for the Company. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec August 15th, 1959, Vol.91, No.S3 3273 Département de l'Instruction publique \\ 25-50.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE LA PAROISSE DE RÉCANCOURT il a phi au Lieutenant-gouverneur en conseil, pai arrêté en conseil en date du 29 juillet 1959 d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire du village de Récancourt, dans le comté de Nicolet, à la municipalité scolaire de la paroisse de Bécaneourt, même comté et de changer le nom de cette dernière, en celui de \"Lu municipalité scolaire de Bécaneourt, dans le comté de Nicolet\".Ces changements prendront effet au premier juillet 1900.Québec, le 11 août 1959.i.e Surintendant de l'Instruction publique, 51247-0 O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.25-59.SCHOOL MUNICIPALITY OF THE PARISH OF RÉCANCOURT His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated July 29, 1959, has been pleased to annex the present territory of the school municipality of the village of Récancourt, in the county of Nicolet, to the school municipality of the parish of Bécaneourt, same county and to change the name of the latter, into that of \"The school municipality of Bécaneourt, in the county of Nicolet\".These changes will take effect on July 1st, 1960.Quebec, August 11, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 51247 Superintendent of Education.N° 348-57.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE ROXBORO Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Côte St-Rémi de Stc-Geneviève N° 4, dans le comté de Jacques-Cartier, le lot 291 du cadastre officiel de la municipalité de Dollard des Ormeaux, pour l'annexer, pour les contribuables catholiques seulement', à la municipalité scolaire catholique de Roxboro, dans le même comté.Québec, le 11 août 1959.I.e Surintendant de l'Instruction publique, 51248-33-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.348-57.SCHOOL MUNICIPALITY OF ROXBORO Application is made to detach from the school municipality of Côte St.Rémi de Ste-Geneviève No.4, in the county of Jacques-Cartier, lot 291 of the official cadaster of the municipality of Dollard des Ormeaux, in order that it be annexed, for Catholic ratepayers only, to the Catholic school municipality of Roxboro, in the same county.Quebec, August 11, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 51248-33-2 Superintendent of Education.N 722-59.MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE-DES-SAULES Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Ste-Moniquc-des-Saules, dans le comté de Québec, en celui de \"Les Saules\", même comté.Québec, le 6 août 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 51249-33-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.No.722-59.MUNICIPALITY OF STE-MONIQUE-DES-SAULES Application is made to change the name of the school municipality of Ste-Moniquc-des-Saulcs in the county of Quebec, into that of \"Les Saules\", same county.Quebec, August 6, 1959.0.J.DÉSAULNIERS, 51249-33-2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS < adastre officiel du village de Aylmcr (munici-l> lité de ville de Aylmer) division d'enregistrement de Gaiincau Avis est par la présente donné que les lots 2188 et 2189 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A \u2022I\" \"ode civil.Québec, le 30 juillet 1959.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 51199-0 A VILA BÉDARD.Department of Lands and Forest NOTICE Official cadastre of village of Aylmcr (municipality of town of Aylmer) registration division of Gatineau Notice is hereby given that lots 2188 and 2189 are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec.July 30, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD.51199-0 Deputy-Minister. 3274 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 88 Cadastre officiel du village de St-Rémi (municipalité de ville de St-Rémi), division d'enregistrement de Napierville.Avis est par la présente donné que le lot 1-3 (rue) est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 29 juillet 1959.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 51199-0 A VILA BÉDARD.Officiai cadastre of village of St-Rémi (municipality of town of St-Rémi), registration division of Napierville Notice is hereby given that lot 1-3 (Street has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, July 29, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.A VILA BÉDARD, 51 l99-o Deputy-Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Beauport (municipalité de Ste-Thérèse-de-Lisieux), division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 902 et 903 est annulée et le lot 1544 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 30 juillet 1959.Le Département des Terres et Forets, Service du Cadastre.Le Sous-ministre.51199-0 A VILA BÉDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Beauport (municipalité de Ste-Thérèse-de-Lisieux), division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 1260 à 1271, 1273 et partie des lots 1259 et 1274 sont annulés et le lot 1543 est ajouté en vertu de l'article 2174A du ('ode civil.Québec, le 27 juillet 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 51199-o AVI LA BÉDARD.Cadastre officiel du canton de Stanstead, division d'enregistrement de Stanstead.Avis est par la présente donné que les lots 496-1 à 496-18 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 30 juillet 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 51199-o A VILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Beauport, (municipality of Ste-Thérèse-de-Lisieux), registration division of Quebec.Notice is hereby given that a part of lots 902 and 903 has been cancelled and lot 1544 has been added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, July 30.1959.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch.AVILA BÉDARD.51199-0 Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Beauport (municipality of Ste-Thérèse-de-Lisieux).registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 1260 to 1271, 1273 and part of lots 1259 and 1274 arc cancelled and lot 1543 has been added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, July 27.1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD 51199-o Deputy Minister.Official cadastre of township of Stanstead.regis-tration division of Stanstead.Notice is hereby given that lots 49(5-1 to 496-18 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Québec, July 30, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD 51199-o Deputy-Minister.Examen du Barreau Bar Examination BARREAU D ' A BITIBI -T É MISC A MIN G U E \u2014 BAH OF ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Candidats pour i.'admission à i.'étude du droit Candidates for the admission to the study of law Noma Names\tPrénoms Surnames\tAge\tResidence Residence Côté.\t\t20 21\tMalartic.Rouyn.\t\t\t \t\t\t Val d'Or, le 7 aoftt 1959.\u2014 Val d'Or.August 7.1959.Le Secrétaire-trôsorier du Barreau d'Aibitibi-Témiscamingue, JEAN BEAULIEl'.51246-0 Secretary-treasurer of Abitibi-Tômiscainiiigue I'\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1969, Vol.91, No.83 3275 Liquidation \u2014 Avis de (P.G.11265-58) MULDERS & REALTORS LIMITED \\\\is est «lonné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie \"Builders & Realtors Limited\", tenue à Montréal le 19 décembre 1957, il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite compagnie soient liquidées volontairement, et que celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, S.R.Q.1941, chapitre 278, et que M.Pierre Goyette, de Montréal, a été nommé liquidateur.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le cinq août 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 51206-o RAYMOND DOUVILLE.Winding up Notices (A.G.11265-58) BUILDERS & REALTORS LIMITED Notice is given that, at a special general meeting of the shareholders of the company Builders & Realtors Limited\", held at Montreal December 19, 1957.it bas been unanimously resolved that the affairs of the said company shall be voluntarily wound up and that the latter be dissolved, pursuant to the provisions of the Winding-up Act, R.S.Q.1941, chapter 278, and that Mr.Pierre Goyette, of Montreal, has been appointed liquidator.Given at the office of the Provincial Secretary, the fifth day of August.1959.RAYMOND DOUVILLE, 51206 Assistant Secretary of the Province.Office des Marchés Agricoles du Québec AVIS D'AMENDEMENT \"Le plan conjoint des Producteurs de Bois de Lévis-Bellechasse\".L'avis de sanction du \"Plan conjoint des Producteurs de Bois de Pulpe de Lévis-Bellechasse\".publié dans la Gazette officielle du 11 octobre 1958, est amendé comme suit: En ajoutant, au chapitre des \"pouvoirs et attributions\", dans la sous-section \"Et particulièrement\", le paragraphe suivant: p) coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors de la province, de tout produit commercialisé, et exercer à celte fin les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d'une autre juridiction prévoyant une telle coopération.Montréal, le 12 août 1959.Le Président, (Juge) GEORGES-H.HÉON.Le Secrétaire, 51260-o LÉONARD ROY.Quebec Agricultural Marketing Board N( )TI( JE OF AM EN DMENTS \"The Lévis-Bellechasse Pulpwood Producers' joint plan\".The notice of sanction of the \"Lévis-Bellechasse Pulpwood Producers' joint plan\", published in the Quebec Official Gazette of October 11th, 1958, is amended as follows: By adding to the chapter \"Powers and attributions\", in the subsection \"Ami particularly\", the following paragraph: p) to co-operate with similar bodies in Canada for the marketing, outside the Province, of any marketed product, and exercise for that purpose the powers and perform the duties accruing to it under any law of another jurisdiction providing for such co-operation.Montreal.August 12th, 1959.(Judge) GEORGES-H.H EON, Chairman.LÉONARD ROY, 51260-o Secretary.Sièges sociaux Head Offices LES APPARTEMENTS BERRI APARTMENTS LTÉE Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Les Appartements Berri Apartments Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes le 24 avril 1959 a établi son bureau et siège social à 354 avenue Outremont, cité d'Ou-tremont, district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Outremont, ce 3 juin 1959.Les Appartements Berri Apartments Ltée, Par le Président, 51207-o FRANÇOIS CORDEAU.LES APPARTEMENTS BERRI APARTMENTS LTÉE Notice is hereby given that \"Les Appartements Berri Apartments Ltée\", company incorporated by letters patent bearing the date of April 24th, 1959, has established its office at 354 Outremont Ave, city of Outremont, district of Montreal, Province of Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Outremont, this 3rd day of June, 1959.Les Appartements Berri Apartments Ltée, Per FRANÇOIS CORDEAU, 51207-o President. 327G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 août 1959, Tome 91, N° 38 LIBRAIRIE UNIVERSELLE INC.Avis est donné que la compagnie \"Librairie Universelle Inc.\" const ituée en corporation par lettres patentes en date du 23 avril 1959 et ayant son bureau principal dans Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 5621.Côte des Neiges, l'a transporté à 5165, vCÔte des Neiges.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant, son bureau principal.Donné à Montréal, ce 5ème jour d'août 1959.(Sceau) 1a: Secrétaire.51208-o JEAN-MARIE NADEAU.ERNEST (ARRIÈRE (1959) INC.Avis est donné que \"Ernest Carrière (1959) Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec en date du 20 juin 1959 et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 2540 est, rue Notre-Dame, dans ladite cité.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal.le 30 juin 1959.Le Président, 51209-o ERNEST CARRIÈRE.LIBRAIRIE UNIVERSELLE IN< Notice is hereby given that the company \"Librairie Universelle Inc.\" incorporated by letters patent dated April 23, 1959 and tuning its bead office in Montreal where its office lias been situated to this date at number 5021.Cute des Neiges, has transferred it to 5165 Côte des Neiges.From and after the date of the present ni t ice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 5th day of August 1959.(Seal) JEAN-MARIE N A DE AI 5120S Secretary.ERNEST CARRIÈRE (1959) INC.Notice is hereby given that \"Ernest Carrière (1959) Inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of the Quebec Coin] >anies' Act on the 20th day of June, 1959 and having its bead office in the city of Montreal, has established its office at 2540 Notre-Dame Street East, in the said city.*fy From ami after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the bead office of the company.Dated at Montreal, this 30th day of \u2022lune, 1959.ERNEST CARRIÈRE, 51209-o President.GEN-TEC LTD.Avis est donné (pie la compagnie \"Gen-Tee Ltd.\", constituée en corporation en date tin 22 mai 1959, a établi son bureau au numéro 3(50, rue St-Roch, de la cité de Québec.Québec, 18 juin 1959.Ix' Président, 51210-o T.WTLDI.GEN-TEC LTD.Notice is given that the company \"Gen-Tec Ltd.\", incorporated on May 22, 1959.has i ~ta-blished its office at number 360 St-Roch Street, in the city of Quebec.Quebec, June 18.1959.T.WILDI.51210 President.MENUISERIE EVAIN WOODWORK INC.Avis est donné que la compagnie \"Menuiserie Evain Woodwork Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 mai 1959 a établi son bureau dans le village d'Evain, district de Rouyn-Noranda.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré comme étant le bureau principal de la compagnie.Donné à Evain.ce 21ième jour de mai 1959.Le Secrétaire, 5121 l-o RAYMOND ROY.OUTREMONT HEIGHTS LTD.Avis est.par les présentes, donné que la compagnie \"Outremont Heights Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes, en date du 6e jour de niai 1959, et ayant son siège social en la cité de Montréal, a établi son bureau à chambre 505, 901 Carré Victoria.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège soeial.Daté à Montréal, P.Q., ce 10e jour de juin 1959.Ix* Secrétaire-trésorier, 51212 MARGOT M.QUINN.MENUISERIE EVAIN WOODWORK INC.Notice is hereby given that \"Menuiserie Evain Woodwork Inc.\", incorporated by letters patent under date on May 20th, 1959 and having its bead office in the town of Evain, district of Rouyn-Noranda, has established its principal office in the said town.As and from this date, the said office is considered by the company as being its principal office.Dated at Evain, this 21st day of May.1959.RAYMOND ROY.5121 l-o Secretary.OUTREMONT HEIGHTS LTD.Notice is hereby given that \"Outremont Heights Ltd.\", incorporated by letters patent on the 6th day of May, 1959, ami having its bead office in the city of Montreal, has established its office at Room 505, 901 Victoria Square.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the eompanylas being the head office of the company.Dated at Montreal, P.Q., this 16th daj of June, 1959.MARGOT M.QUINN.51212-o Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.S3 3277 HÔPITAL LONGUKUIL INC.Avis est donnée que la compagnie \"Hôpital Longueuil Inc.\", cons' ituée en corporation par lettres patentes accordées en date du 15 avril 1959 et ayant son siège social dans la cité de Longueuil a établi son^bureau au numéro 311, du boulevard Quinn.i compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 25ième jour de juin 1959.Le Secrétaire, BÉATRICE CASTONGUAY MELANÇON.51218-0 HÔPITAL LONGUEUIL INC.Notice is given that the company \"Hôpital Longueuil Inc.\", constituted as a corporation by letters patent granted under date of April 15, 1959, and having its head office in the city of Longueuil has established its office at number 311 Quinn Boulevard.From ami after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this twenty-fifth dav of June 1959.BÉATRICE CASTONGUAY MELANÇON, 51218 Secretary.ROBERT FRENETTE INC.Avis est donné (pie la compagnie \"Robert Frenette Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 avril 1959, et ayant son bureau principal aux Trois-Rivièrcs a établi son bureau au numéro 2490 de la rue Gui-mont en la cité de Trois-Rivièrcs.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné aux Trois-Rivièrcs, ce 2e jour d'août 1959.51239 ROBERT FRENETTE.ROBERT FRENETTE INC.Notice is given that the company \"Robert Frenette Inc.\", incorporated by letters patent dated April 20, 1959, and having its head office at Trois-Rivières, lias established its office at number 2490 Guimont Street in the city of Trois-Rivières.From and afterr the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Trois-Rivièrcs.this 7th dav of August, 1959.51239-o ROBERT FRENETTE.THE GREAT WATCHICHOU COMPANY LTD.Avis est.par les présentes, donné que la compagnie \"The Great Watchichou Company Ltd.\", con-tituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie \u2022le la Loi des compagnies de Québec, le 31e jour d'octobre 1955, et ayant son siège social en les cité et district de Québec, où jusqu'il ce joui-son bureau était situé à suite 009, 05, rue Stc-Annc, Québec, l'a transporté à suite 711, 05, rue Ste-Anne, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit In: i au est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Québec, P.Q., ce 24e jour de juin 1959.L'Assistant-Secrétaire, 5124 i -o THÉRÈSE des RIVIÈRES.MAYER ENTERPRISES LTD.Avis est, par les présentes, donné que la com-pagnie \"Mayer Enterprises Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 6e jour d'avril 1959, et ayant son sièj social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 7,881 boulevard Décarie.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social., Daté en la cité de Montréal, ce 13e jour de J'iil! 1959.Le Secrétaire-trésorier, 5124! ANDRÉ MAYER.THE GREAT WATCHICHOU COMPANY LTD.Notice is hereby given that \"The Great Watchichou Company Ltd.\".incorporated by letters patent imdcr Part I of the Quebec Companies' Act on the 31st day of October, 1955, and having its head office in the city and district of Quebec, where its office was situated up to to-day at Room 009, 05 St.Anne St., Quebec, has moved it to Room 711, 65 St.Anne St., Quebec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the bead office of the company.Dated at Quebec, P.Q., this 24th dav of June, 1959.THÉRÈSE des RIVIÈRES, 51241-o Assistant-Secretary.MAYER ENTERPRISES LTD.Notice is hereby given that \"Mayer Enterprises Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 6th day of April 1959, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 7881 Décarie Rlvd.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 13th day of July, 1959.ANDRÉ MAYER, 51244-o Secretary-Treasurer. 3278 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 38 Soumissions Tenders LA COMMISSION DES ECOLES CATHOLIQUES D'A H VIDA (Comté tic Jonquière-Kénogami) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné Paul Gaudreault, secrétaire-trésorier, 340 rue Mellon, Arvida, comté de Jonquière-Kénogami, jusqu'à 3h.30 de l'après-midi, mercredi, le 2 septembre 1959, pour l'achat de §825,000.00 d'obligations de la Commission des Écoles catholiques d'Arvida, comté de Jonquière-Kénogami, datées du 1er juillet 1959 et remboursables par séries du 1er juillet 1900 au 1er juillet 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à ni supérieur à 5J/->% par année, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Deuxième et dernière tranche de la résolution du 1 er mai 1959 au montant total de 81,025,000.00 : \u2014 $825,000.00 \u2014 construction d'une école secondaire de 24 classes et dépenses incidentes, etc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul «l'intérêt sera fait à compter du 1er octobre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $826,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juillet 1960.824,000.00 1er juillet 1961.25,000.00 1er juillet 1962 .27,000.00 1er juillet 1963 .28,000.00 1er juillet 1964 .30,000.00 1er juillet 1965 .31,000.00 1er juillet 1966.32,000.00 1er juillet 1967 .34,000.00 1er juillet 1968.36,000.00 1er juillet 1969 .38,000.00 1er juillet 1970 .40,000.00 1er juillet 1971.43,000.00 1er juillet 1972 .45,000.00 1er juillet 1973 .47,000.00 1er juillet 1974 .50,000.00 1er juillet 1975 .53,000.00 1er juillet 1976 .56,000.00 1er juillet 1977.59,000.00 1er juillet 1978 .62,000.00 1er juillet 1979 .65,000.00 De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Arvida.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas racbetables par anticipation avant le 1er juillet 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er juillet 1967 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er juillet 1969 inclusivement si elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'auto- THE CATHOLIC SCHOOL COMMISSION OF ARVIDA (County of Jonquière-Kénogami) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Ronds\" will |(e received by the undersigned Paid Gaudreault Secretary-Treasurer, 346 Mellon Street.Arvida, county of Jonquière-Kénogami, until 3.30 o'clock p.m.Wednesday, September 2.1959.for the purchase of an issue of 8825,000.00 bonds for the Catholic school commission of Arvida.eountv of Jonquière-Kénogami, dated July 1st.1959, and redeemable serially from July 1st, HiiJO to July 1st.1979 inclusively, with interest at a rate not less than 4V£% nor more than h\\/£/Q per annum payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Second ami last instalment of the May 1st, 1959 resolution for the total amount of Si ,625,000.00: \u2014 $825,000.00 \u2014 construction of a secondary school of 24 classes and incidentale expenses, etc.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from October 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $825,000.00 \u2014 20 years Year Capital July 1st, 1960.$24,000.00 July 1st, 1961.25,000.00 July 1st, 1962.27,000.00 Julv 1st, 1963 .28,000.00 July 1st, 1964 .30,000.00 Julv 1st, 1965 .31,000.00 July 1st, 1966 .32,000.00 July 1st, 1967 .34,000.00 July 1st, 1968 .36,000.00 Julv 1st, 1969 .38,000.00 July 1st, 1970 .40.000.00 July 1st, 1971.43,000.00 Julv 1st, 1972 .45,000.00 July 1st, 1973.47,000.00 July 1st, 1974 .50,000.00 July 1st, 1975 .53,000.00 July 1st, 1976 .56,000.00 Julv 1st, 1977.,59,000.00 July 1st, 1978 .62,000.00 July 1st, 1979 .65,000.(Ml Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Arvida.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as w ell as ; I the head office of the said bank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to July 1st, 1966 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to July 1st, 1967 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, and prior to July 1st.1SI69 inclusively, if issued for a twenty-year term, alter which dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91.Xo.33 3279 rite du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt ; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 2 septembre 1959, a 3.30 heures de l'après-midi, à 340 rue Mellon, Arvida, comté de Jonquière-Kénogami.Ix's commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Arvida.(Comté de Jonquière-Kénogami), ce 7 août 1959.Le Secrétaire-trésorier.PAUL CAUDREAULT.346, rue Mellon, Arvida, (Jonquière-Kénogami), P.Q.Téléphone: Liberté 8-5101.51219-o subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Wednesday, Sepgember, 2, 1959, at 3.30 o'clock p.m., at 346 Mellon Street.Arvida, county of Jonquière-Kénogami.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Arvida, (County of Jonquière-Kénogami) August 7.1959.PAUL GAUDREAULT, Secretary-Treasurer.346, Mellon Street, Arvida.(Jonquière-Kénogami).P.Q.Telephone: Liberté 8-5101.51219 LES COMMISSAIRES D'ÉCOLES POUR LA MUNICIPALITÉ DE ST-CAMILLE (Comté de Wolfe) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné Irénée Paré, secrétaire-trésorier, St-Camille, comté de Wolfe, jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi, le 2 septembre 1959, pour l'achat de $70.000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité «le St-Camille, comté de Wolfe, datées du 1er septembre 1959 et remboursables par séries du 1er septembre 1960 au 1er septembre 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4%% ni supérieur à 5i^% par année, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 19 mai 1959, telle «pic modifiée \u2014 construction d'une école élémentaire de cinq classes.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er octobre 1959.I.e tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 §70,000.00 \u2014 SO ans Année Capital 1 er septembre 1960.x $21,500.00 1 er septembre 1961.x 23,000.00 1 er septembre 1962.1,000.00 1 er septembre 1963.1,000.00 1 er septembre 1964.1,000.00 I er septembre 1965.1,000.00 1 er septembre 1966.1,000.00 I er septembre 1967.1,000.00 1 er septembre 1968.1,000.00 1 er spetembre 1969.1,500.00 I er septembre 1970.1,500.00 1er septembre 1971.1,500.00 1er septembre 1972.1,500.00 1 cr septembre 1973.1,500.00 1 er septembre 1974.1,500.00 1er septembre 1975.1,500.00 1 er septembre 1976.2,000.00 1er septembre 1977.2,000.00 I er septembre 1978.2,000.00 1 er septembre 1979.2,000.00 THE SCHOOL COMMISSIONERS FOR THE MUNICIPALITY OF ST-CAMILLE (County of Wolfe) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Irénée Paré, Secretary-Treasurer, St-Camille, county of Wolfe, until 8.00 o'clock p.m.Wednesday, September 2nd, 1959, for the purchase of an issue of $70,-000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of St-Camille, county of Wolfe, dated September 1st, 1959 and redeemable serially from September 1st, 1960 to September 1st, 1979 inclusively, with interest at a rate not less than 4%% nor more than 5î^% per annum, payable semi-annually on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated May 19th, 1,959 as amended \u2014 construction of a five-classroom elementary school.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from October 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 970,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1960.x $21,500.00 September 1st, 1961.x 23,000.00 September 1st, 1962.1,000.00 September 1st, 1963.1,000.00 September 1st, 1964.1,000.00 September 1st, 1965.1,000.00 September 1st, 1966.1,000.00 September 1st, 1967.1,000.00 September 1st, 1968.1,000.00 September 1st, 1969.1,500.00 September 1st, 1970.1,500.00 September 1st, 1971.1,500.00 September 1st, 1972.1,500.00 September 1st, 1973.1,500.00 September 1st, 1974.1.500.00 September 1st, 1975.1,500.00 September 1st, 1976.2,000.00 September 1st, 1977.2,000.00 September 1st, 1978.2,000.00 September 1 st, 1979.2,000.00 3280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 19Ô9, Tome 91, N° 38 Les \"x\" indûment les années durant lesquelles les versements annuels «l'un octroi total de $46,-350.00.accordé par le Secrétaire de la province et payable en deux versements de §23,175.00 chacune, en 1900 et en 1901, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Asbestos, comté de Richmond.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas racbetablcs par anticipation avant le 1er septembre 190() inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er septembre 1907 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er septembre 1909 inclusivement si elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix otfert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 2 septembre 1959, si 8.00 heures du soir, en la salle du conseil, St-Camille, comté de Wolfe.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Camille, (Comté de Wolfe), ce 7 août 1959.Le Secrétaire-trésorier, IRÉNÉE PARÉ.St-Camille, (Wolfe), P.Q.Téléphone: 25 sonnez 12.51220-o The \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $40.350.00, granted by the Procincial Secretary anil payable in two instalments of $23,175.00 each in 1960 and in 19151, will be received ami applied to the service of this loan.In addition, tenders may be sent and .\u2022.hall he considered for ten-year short-term bonds or for fifteen-year short-term bonds.Howevei the tenders shall be for one only of the above terms.'Hie award shall be made according to law.'Ilie successful tenderer agress to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, hv certified cheque payable at par at Asbestos, county of Richmond.Capital and interest are payable at all I \u2022ranches in the Province of Quebec of tin bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be callable before September 1st.19156 inclusively if issued at ten-year short-term, before September 1st, 1967 1967 inclusively if issued at fifteen-year short-term, and before September 1st, 1969 inclusively if issued for the twenty-year-term; after these latter dates, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in wdiole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must bej accompagnied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.Hie tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to 1\" held on Wednesday, September 2nd, 1959.a! \\(H) o'clock p.m., at the Council Hall, St-Camille, county of Wolfe.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders, St-Camille, (County of Wolfe), this 7th of August, 1959.IRÉNÉE PARI Secretary-Treasurer.St-Camille, (Wolfe), P.Q., Telephone : 25 ring 12.51220 VILLE DE LA MALBAIE (Comté de Charlevoix) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné P.-R.Bouliane, secrétaire-trésorier, 7 rue Nairn, La Malbaic, comté de Charlevoix, jusqu'à 7h.30 du soir, lundi, le 31 août 1959, pour l'achat de $125,000.00 d'obligations de la ville de La Malbaie, comté years Year Capital February 1st, 1960.$ 6,001) 00 February 1st, 1961.6,500.0(1 February 1st, 1962 .7,000.00 February 1st, 1963 .7,500.00 February 1st, 1964.8,000.till February 1st, 1965.15,000 00 February 1st, 1966.17.000 00 February 1st, 1967.17,500.00 February 1st, 1968.18,000.00 February 1st, 1969.19,500.00 February 1st, 1970.20,000.00 February 1st, 1971.22,000.OH February 1st, 1972.22,000 00 February 1st, 1973 .24,000.00 February 1st, 1974.25,500.00 February 1st, 1975.27,000.00 February 1st, 1976 .27,500.00 February 1st.1977 .29,500.00 February 1st, 1978.31,000 On February 1st, 1979.32,000.00 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as 9l/2 year short-term and 11!^ years short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of three terms only.Adju-dicaion shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by, certified cheque payable at par at Levis, county of liévis.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to February 1st, 1966 inclusively, if issued as 9i^ year short-term bonds, prior to February 1st, 1967 inclusively, if issued as 141^2 year short-term bonds, and prior to February 1st, 1969 inclusively, if issued for a 19) _> year term, after which dates the bonds are.under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a cert ilied cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened ami considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, September 1st, 1959, at 8.00 o'lock p.m., at the City Hall, 8 Fraser Street, Levis, county of Levis.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders Levis, (County of Levis), August 10, 1950.PIERRE LEMIEUX.City Clerk-City Hall, 8 Fraser Street, Levis, (Levis), P.Q.Telephone : TErminus 7-9311.51254 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol, 91, No.S3 3283 VILLE DE FABREVILLE (Comté «le Laval) Avis public est par les présentes donné que «les soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné .Mr Gaston Vaillancourt, N.P., secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 heure du soir, à 202 Boni.Sic Hose, Ste-Rosc, (Laval), ou jusqu'à 8.00 hemes du soir, à 216, Boni.Ste-Rosc, Ste-Rose, (bavai), mercredi, le 2 septembre 1959, pour l'achat de $748,000.00 d'obligations «le la ville de Fabreville, comté de Laval, datées du 1er septembre 1959 et remboursables par séries «lu 1er septembre 1960 au 1er septembre 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à |i ,' ni supérieur à 5^% par année, payable se-iiii-aiinuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunt Nos 123:8355,000.00-travaux d'égouts; 132: 8181.000.00 \u2014 construction d'une usine pour le traitement .«les eaux usées; 133: 866,000.00 \u2014 travaux d'égouts; 134: 817,300.00 \u2014 acquisition de terrain; 135: $24,-000.00 \u2014 creusage «le puits et construction d'une station de pompage; 136: 834,000.00 \u2014 travaux d'égouts et «l'aqueduc; et 142: $7J,000.00 travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er octobre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau (l'amortissement \u2014 $7Jt8,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er septembre 1960.825,500.00 1er septembre 1961.26,500.00 1er septembre 1962.27,500.00 1er septembre 1963.28,000.00 i er septembre 1964.;.28,000.00 I er septembre 1965.30.000.00 I er septembre 1966.31,000.00 b-,-septembre 1967.34,000.00 1er septembre 1968.34,000.00 1 er septembre 1969.36,500.00 1er septembre 1970.38,500.00 I er septembre 1971.38,500.00 1er septembre 1972.42.000.00 1er septembre 1973.42,000.00 1er septembre 1974.44,500.00 I er septembre 1975.44,500.00 1er septembre 1976.46,000.00 I er septembre 1977.48,000.00 1er septembre 1978.50,500.00 I er septembre 1979.52,500.00 De plus, des soumissions pourront être envoyées cl seront considérées pour des obligations à courte; échéance dix ans ou à courte échéance Quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul «les trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Ste Rose, comté de Laval.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec «le la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation avant le 1er septembre 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er septembre 1967 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er septembre 1969 inclu- TOWN OF FABREVILLE (County of Laval) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Me Gaston Vaillancourt, X.P., Secretary-Treasurer, until 7.30 o'clock p.m., at 202 Ste.Rose Boulevard, Ste.Rose, (Laval), or until 8.00 o'clock p.m., at 216 Ste.Rose Boulevard, Ste.Rose, (Laval), Wednesday, September 2, 1959, for the purchase of 8748,000.00 of bonds of the town of Fabreville, county of Laval, dated September 1st, 1959 and redeemable serially from September 1st, 1960 to September 1st, 1979 inclusively, at a rate of not than 414% nor more than 5>^% per annum, payable .semi-annually, on March 1st and September 1st of each year.The rate f interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan By-laws Nos 123: 8335,000.00 \u2014 sewer operations; 132: 8181,000.00 \u2014 building of a plant for used waters; 133: 866,000.00 \u2014 sewer and.waterworks operations; 134: 817,300.00 \u2014 purchasing of land; 135: 824,000.00 \u2014 sinking of a well and the building of a pumping station; 136 : 834,000.00 \u2014 sewer ami waterworks operations; and 142: 871,000.00 \u2014 waterworks, sewage operations and road labour.For adjudication purposes only; interest shall be Calculated as from October 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Tabic of redemption \u2014 $71,8,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1960 .$25,000.00 September 1st, 1961 .26,500.00 September 1st, 1962 .27,500.00 September 1st, 1963 28,000.00 September 1st, 1964 .28,000.00 September 1st, 1965 .30,000.00 September 1st, 1966 .31.000.00 September 1st, 1967 .34,000.00 September 1st, 1968 .34,000.00 September 1st, 1969 .36,500.00 September 1st, 1970 .38,500.00 September 1st, 1971 .38,500.00 September 1st, 1972 .42,000.00 September 1st, 1973 .42,000.00 September 1st, 1974 .44,500.00 September 1st, 1975 .44,500.00 September 1st, 1976 .46,000.00 September 1st, 1977 .48,000.00 September 1st, 1978 .50,500.00 September 1st, 1979 .52,500.00 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term an«l fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Ste.Rose, county of Laval.Capital and interest payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior t«> September 1st, 1966 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to September 1st, 1967 inclusively, is issued as fifteen-year short-term bonds, and prior to September 1st, 1969 inclusively, if issued for a 3284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 88 sivement si elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 2 septembre 1959, à 8.00 heures du soir, en la salle municipale de la ville de Ste-Rosc, 210, Boul.Ste-Rosc, Stc-Rose, comté de Laval.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Stc-Rose, (Comté de Laval), ce 12 août 1959.Le Secrétaire-trésorier, Me GASTON VAILLANCOURT, N.P., Adresse postale: 202 Roui.Ste-Rose, CP.709, Ste-Rosc, (Laval), P.Q.Téléphone: NAtional 5-3143.51355-o CITÉ DE SHERBROOKE (Comté de Sherbrooke) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné H.-P.Emond, greffier, Hôtel de Ville, Sherbrooke, jusqu'à 4.00 heures de l'après-midi, lundi, le 31 août 1959, pour l'achat de $2,800,-000.00 d'obligations de la cité de Sherbrooke, comté de Sherbrooke, datées du 1er octobre 1959 et remboursables par séries du 1er octobre 1960 au 1er octobre 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux de par année, payable semi-annuelleinent les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Règlements d'emprunt Nos: 811 \u2014 8143,000.00 sur $156,000.00, travaux d'électricité; 844 \u2014 $88,000.00 sur $94,000.00, travaux d'aqueduc et d'égouts; 845 \u2014 8144.000.00 sur $149,000.00, travaux d'électricité; 888 \u2014 $47,000.00 sur 848,-000.00.travaux d'aqueduc et d'égouts; 893 \u2014 8170,000.00 sur 8178,000.00, travaux d'électricité; 913 \u2014 $33,000.00, construction d'une voie d'évitement de chemins de fer pour fins industrielles; 920 \u2014 877,000.00, travaux souterrains; 921 \u2014 8106,000.00, travaux d'électricité; 925 \u2014 §48,000.00 sur §50,000.00.achat de propriétés pour fins industrielles; 937 \u2014 834,000.00 sur §37,000.00, agrandissement d'un immeuble industriel; 940 \u2014 S28,000.00 sur 833,000.00, agrandissement d'une usine; 943 \u2014 833,000.00, achat de terrains pour fins industrielles; 955 \u2014 8130,-000.00, travaux souterrains; 969 \u2014 853,000.00 sur §55,000.00, achat «l'une propriété pour fins industrielles; 970 \u2014 §1,612,000.00, travaux et achats; 990 \u2014 849,000.00, travaux d'aqueduc et d'égouts; et 1015 \u2014 865,000.00, achat d'immeubles pour fins industrielles.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er octobre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$2,860,000.00\u201420 ans Année Capital 1er octobre 1960.8 68,000.00 1er octobre 1961.89,000.00 1er octobre 1962.112.000.00 twenty-year term, after which dates, the said bonds may, under the authority of chapter 212 Revised Statutes of Quebec 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order ol maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a ceil ilied cheque equal to 1% of the amount of thy, pn .n| issue and must specify whether interest accrued (>n the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, September 2, 1959, at 8.00 o'clock p.m., in the Municipal Hall of the town of Ste.Rose, 216 Ste.Rose Boulevard, Ste.Rose, county of Laval.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Ste.Rose, (County of Laval), this August 12.1959.Me GASTON VAILLANCOURT.N.P., Sccretarv-Treasi i nr.Post Office address: 202 Ste.Rose Boulevard, P.B.709, Ste.Rose (Laval) P.Q.Telephone: NAtional 5-3143 51255 CITY OF SHERBROOKE (County of Sherbrooke) Public.notice is hereby given that scaled tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will he received by the undersigned H.-P.Éniond, City Clerk, City Hall, Sherbrooke, until LOO o'clock p.m., Monday, August 31, 1959, tor the purchase of §2.860,000.00 of bonds of the city of Sherbrooke, county of Sherbrooke, dated Ocb ber 1st, 1959 and redeemable serially from October 1st, 1960 to October 1st, 1979 inclusively, al a rate of 5J^% per annum, payable semi-annually, on April 1st and October 1st of each year.Loan by-laws Nos.: 811 \u2014 1143,000.00 of §156.000.00, electricity operations; 8-11 888,-000.00 of 894.000.00, waterworks and sewage operations; 845 \u2014 8144,000.00 of $149,000.00, electricity operations; 888 \u2014 847,000.00 of S48,-000.00, waterworks and sewage operations; 893 \u2014 8170,000.00 of §178,000.00.electricity operations; 913 \u2014 §33,000.00,building of a railroad siding for industrial purposes; 020 \u2014 §77,000.00, underground operations; 921 §106.000.00, electricity operations; 925 \u2014$48,-000.00 of §50,000.00, purchasing of property for industrial purposes; 937 \u2014 §34.000.011 el' §37,000.00, extension to an industrial immoveable; 940 \u2014 828,000.00 of §33,000.00.enlargement of a plant; 943 \u2014 §33,000.00, purchasing of land for industrial purposes; 955 \u2014 S ' 000.00, underground operations; 969 \u2014 S53,-000.00 of §55,000.00, purchasing of a property for industrial purposes; 970 \u2014 $l,612,00iUHl.operations and purchases; 990 \u2014 §49.000.00.waterworks and sewage operations; and 1015 \u2014 §65,000.00, purchasing of immoveables for industrial purposes.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from October 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $2,860,000.00 \u2014 20 yi an Year Capital October 1st, 1960.§ 68,000.00 October 1st, 1961.89,000.00 October 1st, 1962.112,000.00 Ql 7.7.7.7 OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.S3 3285 [er octobre\tL963.\t114,000\t(K) 1er octobre\t1904.\t123,000\t00 l.r octobre\t1965.\t\t00 1 r octobre\t1966.\t.135,000\t00 1er octobre\t1907.\t142.000\t00 1er octobre\t1968.\t117.000\t00 1er octobre\t1969.\t157,000\t00 1er octobre\t1970.\t139.000\t00 1er octobre\t1971.\t146,000\t00 1er octobre\tL072.\t.152.000\t00 octobre\t1973.\t.157.000\t00 1er octobre\t1971.\t.166,000\t00 1er octobre\t\t159.000\t00 lii- octobre\t1976.\t, 16S.000\t00 1er octobre\t1977.\t177.000\t00 1er octobre\t1978.\t189.000\t00 1er octobre 1979.\t\t193,000\t00 idjudicataire s'engage s\t\tpayer les\tobliga- lions, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par i visé, payable au pair à Sherbrooke, be capital et les intérêts sont payables au bureau principal de la banque à charte dont le i oui si mentionné dans la procédure d'emprunt à Sherbrooke, à Montréal, à Québec ou à To-ronto.Lesdites obligations ne seront pas rachctablcs |) anticipation avant le 1er octobre 1909 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité «lu chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées p anticipation, en tout ou en partie, au pair, toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra «*tre accompagnée d'un chèque accepté «'\"gai à 1% tcl «le Ville, 3810 Boul.Léves-que, l/Abord-à-PIouffc, (Laval), ou jusqu'à 8.00 heures du soir, École St-Êdouard, 3733, 2ème rue, L'Abord-à-Plouffe, (Laval), mercredi, le 2 septembre 1959, pour l'achat de $965,000.00 d'obligations de la ville de L'Abord-à-Plouffe, comté de Laval, datées du 1er septembre 1959 et remboursables par séries «lu 1er septembre 1900 au 1er septembre 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4j^% ni supérieur A 53 ( par année, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre «le chaque année.Le taux d'intérêt peut être le limine pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 104 \u2014 travaux permanents: tr«>ttoirs, égouts, conduite d'eau, pavages, etc.Pour fins «l'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter «lu 1er octobre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $965,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1 cr septembre 1900 .840,000.00 I er septembre 1901.40,000.00 I er septembre 1962.40,000.00 1 er septembre 1963 .40,000.00 1er septembre 1964.45,000.00 1er septembre 1965.45,000.00 1er septembre 1966.45,000.00 1er septembre 1967.45,000.00 1er septembre 1968.50,000.00 1er septembre 1969 .50,000.00 1er septembre 1970.50,000.00 1 er septembre 1971.50,000.00 1er septembre 1972.50,000.00 1er septembre 1973.50,000.00 I er septembre 1974.50,000.00 1er septembre 1975 .55.000.00 I er septembre 1976 .55,000.00 1er septembre 9177 .55,000.(M) 1 er septembre 1978.55,000.00 I er septembre 1979.55,000.00 De plus, «les soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à comte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à L'Abord-à-Plouffe, comté de Laval.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi «pi'au bureau principal «le ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er septembre 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er septembre 1967 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er septembre 1969 inclusivement m elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt ; cependant, si tel rachat est partiel, il affec- TOWN OF L'ABORD-À-PLOUFFE (County of Laval) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Vvon Lavoie, Secretary Treasurer, until 7.30 p.m.Town Hall, 3810 Lévesque Boulevard, L'Abord-à-Plouffe, (Laval), or until 8.00 o'clock p.m.St-Edouard school, 3733, 2nd Street, L'Abord-à-Plouffe, (Laval), Weilnesday, September 2, 1959, for the purchase of an issue of 8965.000.00 of bonds for the town of L'Abord-à-Plouffe, county of Laval, dated September 1 st.1 959, and redeemable serially from September 1st, 1960 to September 1st, 1979 inclusively, with interest at a rate not less than ty$o nor more than hYf/o per annum payable semi-annually on March 1st and Sepgcmber 1st of each year.The rate «>f interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law Xo 104: permanent works; sidewalks, sewers, water conduits, pavements, etc.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from October 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $965,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1960 .$40,000.00 September 1st, 1961 .40,000.00 September 1st, 1962 .40,000.00 September 1st, 1963 .40.000.00 September 1st, 1964 .45,000.00 September 1st, 1965 .45,000.00 September 1st, 1966 .45,000.00 September 1st, 1967 .45,000.00 September 1st, 1968 .50.000.00 September 1st.1969 .50,000.00 September 1st, 1970 .50,000.00 September 1st, 1971 .50,000.00 September 1st, 1972 .50.000.00 September 1st, 1973 .50.000.00 September 1st, 1974 .50,000.00 September 1st, 1975 .55,000.00 September 1st.1976 .55,000.00 September 1st.1977 .55,000.00 September 1st, 1978 .55,000.00 September 1st, 1979 .55.000.00 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at L'Abord-à-Plouffe, county of Laval.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to September 1st, 1966 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to September 1st, 1967 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, and prior to September 1st, 1969 inclusively, if issued for a twenty-year term, after which dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed 3288 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql 'ÉliEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 88 fera les échéances les plus eloigners et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du moulant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 2 septembre 1959, à 8.00 heures du soir, en l'école St-Edouard, 3733.2ème rue, L'Abord-à-Plouffe, comté de Laval.Le conseil se réserve le droit, de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.L'Abord-à-Ploufte, (Comté de Laval), ce 12 août 1959.I/c Secret aire-trésorier.YVON LA VOIE.Adresse postale: Hôtel de Ville, 3S10 Boni.Lé-vesque, L'Abord-à-Plouffe, (Laval), P.Q.Téléphone: MUrray 1-1943.5125S-o MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE-DES-SAULKS (Comté de Québec) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné Louis-P.Page, secrétaire-trésorier, Salle du conseil, Kiosque de l'O.T.J., Stc-Monique-des-Saules, comté de Québec, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 31 août 1959, pour l'achat de $800,000.00 d'obligations de la municipalité de Ste-Monique-des-Saules, comté de Québec, datées du 1er septembre 1959 et remboursables par séries du 1er septembre 1900 au 1er septembre 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4y>% ni supérieur à 5^2% par année, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt No 18 \u2014 construction d'un aqueduc et d'un égout municipal.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $800,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er septembre 1900.S 0,000.00 1er septembre 1901.6,000.00 1 er septembre 1962.6,000.00 1er septembre 1963.7,000.00 1 er septembre 1904.7,000.00 1er septembre 1965.8,000.00 1er septembre 1966.8,000.00 1er septembre 1967.9,000.00 1er septembre 1968.9,000.00 1er septembre 1969.10,000.00 1er septembre 1970.10,000.00 1er septembre 1971.11,000.00 1er septembre 1972.11,000.00 1er septembre 1973.12,000.00 1er septembre 1974.12,000.00 1er septembre 1975.13,000.00 1er septembre 1976.14,000.00 1er septembre 1977.15,000.00 1er septembre 1978.15,000.00 1er septembre 1979.611,000.00 De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the pn til issue and must, specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and consider !.t ;: meeting of the Council to be held on Wednesday September 2, 1959, at 8.00 o'clock p.m., .I the St-Edouard School, 3733, 2nd Sired.L'A >ord-à-Plouffe, county of Laval.The council does not bind itself to nca pi the highest or any of the tenders.L'Abord-à-Plouffe, (County of Laval).August 12, 1959.YVON LAYOU, Secretary-Treasurer.Postal address: Town Hall, 3810 Lévcsquc Boulevard, L'Abord-à-Plouffe, (Laval).P.Q, Telephone: MUrray 1-1943.51258 MUNICIPALITY OF STE.MONIQUE-DES-SAULES (County of Quebec) Public notice is hereby given that scaled tenders, endorsed \"Tenders for Ronds\" will be received by the undersigned Louis-1'.Page; Secretary-Treasurer, Council-room, Kiosk of the O.T.J., Ste.Monique-des-Saules, countv of Quebec, until 8.00 o'clock P.M.Monday, August 31, 1959, for the purchase of $800,0 00 of bonds of the municipality of Ste.Monkpic-des-Sàules, county of Quebec, dated September 1st, 1959 and redeemable serially from September 1st, 1960 to September 1st, 1979 includively, at a rate of not less than 414% nor more than 5^t% per annum, payable semi-annually, on March 1st and September 1st of cadi year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan By-law No.18 \u2014 Building of municipal waterworks and sewcr.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from September 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $800,000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1960.8 6,000.00 September 1st, 1961.6.000.00 September 1st, 1962.6,000 00 September 1st, 1963.7,000 00 September 1st, 1964.7,000.00 September 1st, 1965.8,000.00 September 1st, 1966.8,000.00 September 1st, 1967.9,000.00 September 1st, 1968.9,000.00 September 1st, 1969.10,000.00 September 1st, 1970.10,000.00 September 1st, 1971.11,000.00 September 1st, 1972.11,000.01 > September 1st, 1973.12,000.00 September 1st, 1974.12,000.00 September 1st, 1975.13,000.00 September 1st, 1976.14,000.00 September 1st, 1977.15,000.00 September 1st, 1978.15,000.00 September 1st, 1979.611,000.00 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered, for ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of three terms only.Adju- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 16th, 1969, Vol.91, No.S3 3289 devront comporter qu'un seul des trois ternies.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la pro-d'empruht.Lesdites obligations ne seront pas rachetables pa anticipation avant le 1er septembre 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans.avant le 1er septembre 1007 inclusivement si elles sont émises à courte échéance q linze ans, ou avant, le 1er septembre L969 inclusivement si elles sont émises à courte échéance vingt ans: après ces dales, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, cire rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au paix*, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est pai1 ici.il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.( laque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur letrict of Abitibi, P.Q.presently domiciled at Val d'Or P.Q.AVIS DE VENTE L'immeuble connu el désigné connue étant le lot numéro trente-six (36) du rang dix (10) du canton Dalquier, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances: Pour être vendu :i la porte de l'église paroissiale St-Félix de Dalquier, comté d'Abitibi-Est, le SEIZIÈME jour de SEPTEMBRE 1959 à DEUX heures p.m.Bureau du Shérif, Le Shérif.Amos, J.ALFRED GAUTHIER.6 août 1959.51222-33-2-0 NOTICE OF SALE The immoveable known and designated as being lot number thirty-six (36) of range ten (10) of the Dalquier township, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies; To be sold at the parochial church St-Félix de Dalquier, county of Abitibi-East, on the SIXTEENTH day of SEPTEMBER, 1959.at TWO o'clock p.m.Sheriff's Office, J.ALFRED GAUTHIER, Amos, Sheriff.AugustG, 1959.51222-33-2 Fieri Facias tic Bonis et de Terris Cour Supérieure, ( pEO-EXPLORERS LTM-Rouyn-Noranda, ) ^ ITED, une corporation N° 1909.\\ ayant sou bureau principal au ' X° 181 troisième Avenue, Noranda, Que., demanderesse vs OKA-BA-THURST MINING CORPORATION LIMITED (Libre de responsabilité personnelle), une corporation minière ayant son bureau principal au \\'° 455 St-François Xavier, Montréal, Que., défenderesse.La propriété à vendre est la suivante: Tous les droits, crédits pour travaux de prospection et développement faits, titres et intérêts de la défenderesse dans et en vertu de cinq (5) permis de mise en valeur émis par le Ministère des Mines, Québec, P.Q., portant les Nos 29089 à 29693, affectant 1000 acres, plus ou moins, apparaissant, sur les cartes du canton de McCor-kill, P.Q.détenues au Département des Mines, Québec, P.Q., étant cinq (5) claims miniers, piquetés en vertu de chacun des cinq (5) certificats miniers suivants à savoir: N° 88454 à 88457 inclusivement et 91/91.Pour être vendu en bloc au bureau de la Cour du Magistrat à Val d'Or.P.Q., le VINGT-CINQUIÈME jour de SEPTEMBRE 1959, à QUATRE heures TRENTE de l'après-midi, heure avancée de l'est.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, Que., le 7 août 1959.51223-33-2-0 Fieri Fadas de Bonis et de Terris Superior Court, ( pEO-EXPLORERS LIM-Rouyn-Noranda, ) ITED, a corporation No.4909.j having ils bead office al 181 [ Third Avenue, Noranda, P.Q., plaintiff vs OKA-BATHURST MINING CORPORATION LIMITED (NoPersonal Liability), a mining corporation having its head office at 445 St.Francis Xavier St., Montreal P.Q., the defendant.The property to be sold is the following: All the Defendant's rights, credits for prospecting and development work done, title and interests in and under five (5) mining development licenses issued by the Quebec Development of Mines bearing Nos.29089 to 29093, affecting 1000 acres, more or less, shown on the map of McCorkill Township, P.Q., kept at the Department of Alines, Quebec, P.Q., being 5 claims each staked in virtue of the following mining licenses, namely: 88454 to 88457 inclusively and 94791.To be sold as a whole at the Magisti te's Court office at Val d'Or, P.Q., on the TWENTY-FIFTH day of SEPTEMBEY, 1959, at the hour of FOUR THIRTY in the afternoon eastern daylight saving time.J.A.GAUTHIER.Sheriff's Office, Sheriff.Amos.P.Q., August.7, 1959.51223-33-2-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.S3 3293 HEAUCK Fieri Facias de Bonis et de Terris ( 'our Supérieure \u2014 District de Québec St Joseph de Beauce, ( T TXITED LOAN COR-\\° 95-981, J U PORATIOX, cor-à savoir: \\ poration légalement cons-\\ tituée, ayant son principal bureau d'affaires à 120.rue Du l'ont, cité ét district de Québec, contre GEORGES BÉDARD, résidant et domicilié à St-Côme, comté de Beauce, district de Beauce, à savoir: Le lot 13 du rang 7 du canton de Jersey, et les bâtisses dessus construites.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale, en la paroisse de St-Côme.comté de Beauce.le QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, J.S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, le 27 juillet 1959.51132-3l-2-o [Première insertion: 1er août 1959] (Seconde insertion: 15 août 1959] BKAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court\u2014 District of Quebec St.Joseph de Beauce, ( T TNITED LOAN No.95-981, )U CORPORATION, To wit: \\ corporation legally cons- 'tituted, having its principal place of business at 120 Du Pont Street, city and district of Quebec versus GEORGES BEDARI), residing and domiciled at St.Come, county of Beauce.district of Beauce, to wit: Lot 43 of Range 7 of the township of Jersey, and the buildings thereon erected.To be sold at.the door of the parochial church, in the parish of St.Come, county of Beauce, the FOURTH day of SEPTEMBER next at TEN o'clock in the 1'orCnoon.J.S.POULIOT, Sheriff's Office, Sheriff.St.Joseph de Beauce, July 27, 1959._ .51132-31-2 [First insertion: August 1st, 1959] [Second insertion: August 15th, 1959] Fieri Facias de Terris d de Bonis I )ans la Cour de L'Echiquier du Canada, district d'Ottawa St-Joseph de Beauce, ( T A U)l T)E L'IMPÔT \u2022.savoir: < ^ SUR LE REVENU N° 151083.VET AMENDEMENTS contre NOÊ QUIRION du village de St-Robert du comté de Frontenac, à savoir: Les droits-et prétentions ainsi que les améliorations du défendeur sur le lot numéro 1A ram; II.canton Marlow, de la paroisse de St-Robert dans le comté de Frontenac.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale, ( ii la paroisse de St-Robert.comté de Frontenac, le DIX-HUIT]ÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, J.-S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, 12 août 1959.51253-33-2-0 |Première insertion: 15 août 1959] [Seconde insertion: 29 août 1959] Fieri Facias de Hon is et de Terris In the Exchequer Court of Canada District of Ottawa St-Joseph de Beauce.(/ TNCOME TAX ACT, to wit: < i AND A M EN D- No.151083.vMENTS against NOÉ QUIRION, of the village of St-Robert of the county of Frontenac, to wit: The rights and pretentions as well as the improvements of the defendant on lot number 1A, range 11, township of Marlow, of the parish of St-Robert, in the county of Frontenac.To be sold at the parochial church door, in the parish of St-Robert, county of Frontenac, on the EIGHTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.J.-S.POULIOT, Sheriff's Office, Sheriff.St-Joseph de Beauce, August 12, 1959.1253-33-2 [First insertion: August 15, 1959] [Second insertion: August 29, 1959] H K A 1111AItXOIS Fieri Facias de Terris District de Beauharnois Cour Supérieure, t ARTHUR COUILLARD C.S.F.LTÉE, corporation ié- N 1009-1958 | gaiement constituée, ayant \\ son siège social en la cité de Beauharnois, et BENOIT SAUVÉ, vendeur d'huile, de la cité de Beauharnois, dit district, demandeurs, et NORBERT ROUX, entrepreneur, demeurant et faisant affaires à Beauharnois.dit district, sous la raison sociale de \"Beauharnois Excavation Enrg\".et maintenant, de lieux inconnus, défendeur.Et J.C.MARCOTTE, syndic licencié, de la cité de Montréal, district de Montréal, en sa qualité de syndic à la faillite du défendeur ci-dessus désigné.Syndic intimé.A savoir: \"Un emplacement sis et situé sur la rue Julien, en la cité de Beauharnois, connu et désigné comme étant partie du lot numéro cent trente-deux (Ptc.N° 132), des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse St-Clément, comté de beauharnois; mesurant cent quatorze pieds BEAUHARNOIS Fieri Facias de Terris District of Beauharnois Superior Court, ( A RTHUR COUILLARD C.S.F.J LTÉE, a legally incor- No.4009-1958 \\ pointed corporation having 'its head office in the city of Beauharnois, and BENOIT SAUVÉ, oil salesman, of the city of Beauharnois, said district, plaintiffs, and NORBERT ROUX, contractor, residing and carrying on business at Beauharnois, said district, under the style of '\"Beauharnois Excavation Enrg\".and presently of unknown whereabouts, defendant.And J.C.MARCOTTE, licenced trustee of the city of Montreal, district of Montreal, in his quality of trustee in the bankruptcy hereinabove designated.Respondant Trustee.To wit: \"An emplacement located and situated on Julien Street, in the city of Beauharnois, known and designated as being part of loi number one hundred and thirty-two (Pt.No.132), of the official plan and in the book of reference of the parish of St.Clément, county of Beauharnois; 3294 GAZETTE OFF 1(1 EUE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° S3 et vingt-cinq centièmes de pteds dans sa ligne sud-est, cent quatre-vingt-dix-huit pieds, el dix-neuf pieds dans sa ligne brisée sud-ouest le long de la rue Julien, cent pieds dans sa ligne nord-ouest, le long de la ligne de division entre ledit emplacement et le lot N° 132-4, deux cent vingt-trois pieds dans sa ligne sud-ouest, le long de la ligne «le division entre ledit emplacement et les lots Nos.132-1, 132-2, 132-3, cl 132-4, et quatre cent quarante-cinq pieds dans sa ligne nord-est, mesure anglaise, plus ou moins; borné dans une ligne nord-ouest par la Rivière Sl-Louis, et dans une autre ligne nord-ouest par le lot N° 132-4, au nord-est par les lots Nos.131-27, 131-28, 131-29, 131-30, 131-31 cl 131-32, et par une partie non subdivisée dudil lot X° 131, au sud-est par le lot N° 132-10, au sud-ouest par partie dudit lot N° 132, étant la rue Julien, et par les lots Nos.132-1.132-2.132-3 et 132-4\".Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de l'église de Beauharnois, le DIX-SEPTIÈME, jour de SEPTEMBRE 1959, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.ERNEST POIRIER.Salaberry de Yallcyfield, ce 7ième jour d'août 1959.51230-33-2-o (1ère publication: le 15 août 1959] measuring one hundred and fourteen feet and twenty-five hundredths of a foot in ils southeast line, one hundred ami ninety-eight feel and nineteen feel in its broken line southwest along Julien Street, one hundred feet in ils northwest line, along the dividing line between the said emplacement and lot No.132-1, two hundred and twenty-three in its southwest line, along the dividing line between the said emplacement and hits Nos.132-1.132-2, 132-3 and 132-4, and four hundred ami forty-five feel in ils northcnsl line, English measure, more or less; bounded in a northwest line by the St-Louis River, and in another line northwest by lot No.132-4, on the northeast by lots Nos.131-27, 131-28, 131-29 131-30, 131-31 and 131-32, and by an inisub' divided part of the said lot Xo.131.on the southeast, by lot Xo.132-10.on the southwest, by par( of the said lot Xo.132.being Julien Street, and by lots Nos.132-1, 132-2, 132-3 and 132-4\".To be sold at the parochial church door of du.Beauharnois church, on I he SEVENTEENTH .lay of SEPTEMBER, 1959, at TEX o'clock in I he forenoon.ERNEST POIRIER, Sheriff's Office, Sheriff.Salaberry de Vallcyficld, this 7th day August, of 1959.51230-33-2 (1st publication: on August 15, 1959] GASPÉ Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure, i A URÈLE & JOSEPH Rimouski, (J AU DRE AU, Ions N° 15,089.\\ deux garagistes de Cap-Chat ' Est, district de Gaspé et y faisant, affaires ensemble sous la raison sociale de \"Gaudrcau & Gnudreau, Enrg.\", demandeurs, vs PIERRE AMIOT, de l'endroit appelé St-Octave de l'Avenir, district de Oaspé, défendeur.La propriété à vendre est la suivante: Une maison d'habitation sise sur le lot N° 20 rang 9, canton Cap-Chat, comté de (Jaspé-Nord.Pour être vendue à la porte de l'église de St-Octave de l'Avenir, MARDI, le VINGT-CINQUIEME jour d'AOÛT.1959, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, le 20 juillet|1959.51101-30-2-o gaspé Fieri Facia* de lion is et de Terris Superior Court, ( A URÈLE & JOSEPH Rimouski, J-O- G AU DR EA I.both No.15,089.j garage-keepers of Cap-Chat (.East, district of Gaspé and carrying on business together under tin- style of \"Gaudrcau & Gaudrcau, Enrg.\", plaintiffs, vs PIERRE AMIOT, of the place called St-Octave de l'Avenir, district of Gaspé, defendant.The property for sale is the following: A dwelling house situated on lot Xo.20, range 9, township Cap-Chat, county of Gaspé-North.To be sold at the church door of St-Octave de l'Avenir, TUESDAY, the TWENTY-ITFTH day of AUGUST, 1959, at TEN o'clock in the forenoon.J.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.Perce, July the 20th, 1959.51101-30-2 HULL Canada \u2014 Province de Québec District, de Hull Cour Supérieure, j pASTON LEFEBVRE, N° 0335.marchand, domicilié à ^ Buckingham, district de Hull, demandeur, vs GÊRALD ROUSSEL, cultivateur, domicile à Notre-Dame du Laus, dit district, tiers-saisi, & AIMÉ ROUSSEL, de Notre-Dame du Laus, dit.district, était, défendeur.1° \"Un lopin de terre de figure irrégulière formant partie du lot 22, rang 7, de l'arpentage primitif, borné à l'ouest par le rang G; au nord par le lot numéro 23; à l'est par le rang 8 et la rivière Serpent; au sud par le lot numéro 21a; mesurant 13 chaînes à l'ouest, 84 chaînes et 2 mailles au nord, 84 chaînes et 58 mailles au sud, contenant en superficie 109 acres et 59 centièmes; et situé dans le canton McGill, district de Hull.\" HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, 1 pASTON LEFEBVRE, No.0335.\\ merchant, domiciled at '\u2022Buckingham, district of Hull, plaintiff, vs GÊRALD ROUSSEL, farmer, domiciled at Notre-Dame du Laus, said district, garnishee, and AIMÉ ROUSSEL, of Notrc-Dame du Laus, said district, defendant.1.\"A plot of land of irregular shape forming part of lot 22, range 7, of the original survey, bounded westerly by range G; northerly by lof number 23; easterly by range 8 and the Serpent River, southerly by lot number 21a; measuring 13 chains westerly, 81 chains and 2 links northerly, 84 chains and 58 links southerly, containing an area of 109 acres and 59 hundredths; and situated in the McGill township, district of Hulk QUEBEC OFFICIA L GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.33 3295 -\u2014-i______ 2° \"Un lopin de terre de figure irrégulière connu et désigné comme étant le; lot numéro 22a ,ln rang 8 et formant partie du lot 22 de l'arpentage primitif, borné à l'ouest par le rang 7; au nord, par le lot numéro 23a; vers le sud-est ,.( I,.sud-ouest, par la rivière Serpent; mesurant «I chaînes et 50 mailles à l'ouest, 33 chaînes au nord, contenant en superficie 13 acres; et situé dans le canton McGill, district de Hull.\" 3° \"Un lopin de terre de figure irrégulière connu cl désigné comme étant le lot numéro 22b du rang S cl formant partie du lot 22 de l'arpentage primitif, borné à l'ouest par la rivière Serpent; vers le nord-ouest et nord-est par la rivière Serpent; au nord par le lot 23b; à l'est, par le rang 9: au sud.par le lot 21b; vers le sud-ouest, par la rivière Serpent; mesurant une chaîne cl cinquante mailles à l'ouest, 43 chaînes au nord.13 chaînes à l'est; SO chaînes et 50 mailles au sud, contenant en superficie 84 acres d !H centièmes; et situé dans le canton McGill, district de Hull.\" Pour être vendus à la porte de l'église Notre-Dame «lu bans, dit district, le DIX-SE1TIÈME jour «le SEPTEMBRE, 1959, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-ITERRE.ce 8 août 1959.51231-33-2-0 Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure\",Ï T ÉO MÉNARD, de Em-\\° 771} 1.\"[ brun, provinde d'Onta-Wio.et JACQUES PATE-NAUDE, de la cité d'Ottawa, province d'Ontario, tous deux' commerçants, demandeurs, vs (il-,M CONSTRUCTION' CO., LTD., corporation légalement constituée, ayant son siège social en la cité d'Eastview, province d'Ontario, défenderesse.\"Ces parcelles de terrain sises et situées en la ville de Buckingham et plus particulièrement connues et désignées connue étant les subdivisions numéros huit, neuf, dix, onze et douze du lot numéro douze B (12b-S), (12b-9), (12b-10), (12b-ll) et (12b-12) du cadastre officiel pour le troisième rang du canton de Buckingham, maintenant situé dans les limites de la ville de Buckingham, comté de Papineau\".Four être vendues à la porte de l'église, St-Grégoirc de Naziance, en la ville de Buckingham, le DIX-HUITIÈME jour de SEPTEMBRE, 1959, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-PIERRE.ce 1 août, 1959.51232-33-2-o JULIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Joliette Cour Supérieure.( THE CANADA LIFE AS-N° 11,014.< 1 SURANCE COM l'A-^ NY, un corps politique et corporatif, ayant son siège social et principale place d'affaires en la cité de Toronto, province dOntario, et sa principale place d'affaires pour la province de Québec en les cité et district de Montréal, demanderesse et EDOUARD TROT-TIER, travailleur d'usine, domicilié au chemin té, vers le-sud-est, au reste dudit lot 434 ci-après décrit, et de l'autre côté, vers le nord-ouest, au lot numéro 435; 2° De la partie sud-est du lot numéro quatre cent trente-cinq (Ptie s.-e.435) aux susdits plan et livre de renvoi officiels, sans bâtisse, contenant un arpent de largeur sur la profondeur dudit lot numéro 435, soit environ quatre arpents et huit perches, ainsi bornée: d'un bout, vers le nord-est, audit lot numéro 288, à l'autre bout, vers le sud-ouest, aux numéros 421 et 422 dudit cadastre, d'un côté, vers le sud-est, à la partie ci-dessus \"An emplacement fronting on the Chemin de la Petite Assomption in the paris!) of Repcntigny county of l'Assomption, known and designated as being lot number two hundred and two of the oflicial subdivision of original lot number one hundred and twenty-eight (128-202) of the official plan and book of reference of the parish of llcpcn-tigny.With all building thereon erected.As the whole now subsists, with all its rights members and appurtenances and with all active and passive, apparent and unapparenl servitudes attached thereto, without exception or reserve of any kind on the part of the Borrower.In conformity with a judgment rendered in this matter on July 10, 1959, the officer proceeding to the sale is bound to exact from bidder prior to his offer or bid, the deposit in bis bands of an amount of at least nine hundred dollars ($900.00).\" To be sold at the parochial Church door of Repcntigny.county of l'Assomption, Tlil US.DAY the TWENTY-SEVENTH *dav of AI-GUST, 1959, at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERHAI ! Sheriff's Office, Sheriff of Joliette.Joliette, July 21, 1959.51107-30-2 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Joliette Superior Court, ( pAUL FRECHETTE.farm-No.12,009.< A er of St-Norbert.districl '\u2022of Joliette, in his quality of tutor to his daughter, a minor, Diane Frechette, plaintiff, vs DAME SARAH BACON-ROCHE-LEAD, GEORGES AIMÉ ROCHELEAI and ÉMILIEN ROCHELEAU, all three of St-Norbert, district of Joliette, defendant-1.Against Emilien Rocheleau: a) A fram situated in the parish of St-Norberl, on the southwest of the Bonaventure brook, known and designated on the oflicial plan and in the book of reference of the said parish of St-Norbert, under lots numbers three hundred and fifty-three and three hundred and fifty-five* (353-355) containing two arpents and one/ quarter in width along a depth of approximately thirty-eight arpents, more or less, bounded: at one end by the Bonaventure Brook, al the other end by the farms of Ste Elisabeth, on one side, by numbers 354, 352 and on the other side, by number 356, with the buildings thereon erected.b) A wooded farm situated in the said parish of St-Norbert, and composed: 1.From the northwest part of lot number four hundred and thirty-four (Pt.n.-w.434) on the oflicial plan and in the book of reference, without building, containing half an arpcnl i\" width by the depth of the said lot number 134, i.e.approximately thirteen arpents, thus bounded: at one end, on the northeast, by lot number 288, at the other end, on the southwest, by lot number 421, on one side, on the southeast, by the remainder of the said lot 434 hereinafter described, and on the other side, on the northwest, by lot number 435; 2.From the southeast part of lot number four hundred and thirty-five (Pt.s.-e.435) in the above mentioned official plan and book of rc-ference, without building, containing an arpent in width by the depth of the said lot number 135, i.e.approximately four arpents and eight rods, thus bounded: at one end, on the northeast, by the said lot number 288, at the other end, on the southwest, at numbers 421 and 422 of the said QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.33 3297 décrite dudit lot numéro 434, et de l'autre côté, vers le nord-ouest, au résidu dudit lot numéro 435.2.Contre Georges-Aimé Rocheleau: c/) Une terre sitifée en ladite paroisse de St-Norbert, connue et désignée aux susdits plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse de St-Norbert, sous les lots numéros trois cent quarante-huit et trois cent quarante-neuf (348-349), avec les constructions dessus érigées, contenant environ soixante-treize arpents en superficie, de forme irrégulière; à distraire cependant dudit lot numéro trois cent quarante-neuf (349), la portion vendue à Louis Denis, par acte enregistré au bureau d'enregistrement de Ber-ti irr.sous le numéro 28,959, actuellement la propriété de M.Emile Ducharme.b) Une terre à bois située en ladite paroisse de Si Norbert, connue et désignée aux susdits plan et livre de renvoi officiels comme faisant partie du lot numéro quatre cent trente-quatre (434 Ptie), sans bâtisse, contenant un arpent et demi de largeur sur la profondeur dudit lot numéro 434, soit environ treize arpents, ainsi bornée: d'un bout, vers le nord-est, au numéro 289, à l'autre bout, vers le sud-ouest, aux numéros 420-121, d'un côté, vers le sud-est au lot numéro 433.et de l'autre côté vers le nord-ouest, à la sortie dudit lot numéro 434, ci-dessus décrit.3.£Contre Émilien Rocheleau.Le lot numéro 1096 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de St-Norbert, mesurant IW) pieds à sa façade et 3/4 d'arpent à la profondeur compris entre le ruisseau à l'arrière et le chemin à l'avant un chemin de ligne sur un côté l'emplacement -de Georges Laporte et représentants.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de St-Norbert, comté de Rertbier, le MERCREDI, VINGT-SIXIÈME jour du mois d'A:'\u2022ook of reference for the township of Whitton with buildings; \"A morsel of land of ten acres of land in superficies, more or less, to take and to distract at the south-east end of lot number one (Pt.1) of proper range four upon the official plai and book of reference for the township of Whitton, bounded to the north-east by the public road and the line between this range and the fifth range south-west, to the south-east by the line between ranges four and five of Whitton; i the south-west by lot number two of said range four; and to the north-west by the continuation right angle of the division line between lots eighth ami npie-a of said fifth range south-west of the township as far as lot two above mentioned.To be sold \"en bloc\" at the door of the parochial church of Notre-Dame du Bon Const.; de Springhill (Nantes), WEDNESDAY, the SIXTEENTH day of SEPTEMBER, 1959, at TEN o'lock in the forenoon.Sheriff's Office.JOSEPH LABREC JQU E Sherbrooke.Sheriff, this 7th of August, 1959.51228-33 2-o [First insertion: the 15th of August, 1959] Index de la Gazette officielle Index of the Quebec Official de Québec, N° 33 Gazette, No.33 action ex séparation de biens: action for separation as to property: Asselin vs Beaupré.3268 Asselin vs Beaupré.3268 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August lôth, 1959, Vol.91, No.33 3303 Arrêtés en Conseil: , 18-A \u2014 Employés de garages, régions de Roberval, St-Félicien et Dolbeau.3262 7-l.x-B \u2014 Barbier, coiffeur et coiffeuse, district de St-François.3263 748-C \u2014 Alimentation au détail, région de Québec.3264 Assemblée: ( 'orporation de l'Observatoire de Québec 3268 Avis aux intéressés: 3233 Avis divers: Association d'Epargne de Windsor ( Fondation).3270 Association des Chauffeurs et Employés de la Compagnie de Transport Montmorency (Formation).3269 La Caisse d'Établissement Rural de la ( haudière (Fondation).3270 La Caisse Populaire Desjardins de Ste- Marthe de (Jaspé (Fondation).3270 I.Association des Détaillants de la ( 'haussure du Québec \u2014 The Province of Quebec Shoe Retailers Association (Formation).3268 L'Institut de Cardiologie de Québec (Règlements).3271 L'Orchestre Symphonique de Québec (Règlement).3271 Lu-Rich Building Corporation (Dist.de l'actif).3270 Lu-Rich Building Corporation (Règlement).3271 Nairn Falls Pulp Company Ltd.(Dist.de l'actif).\".3269 Nova Dania Home (Règlements).3270 Rusty Lake Mining Corporation (Directeurs) .3269 Syndicat des Producteurs Fournisseurs de Lait à la Laiterie de Sherbrooke Limitée (U.C.C.) (Formation).3268 Chartes \u2014 Abandon de:, Chateaufort Inc.3272 City House Furniture Inc.3272 Lu-Rich Building Corporation.3272 Safari Inc.3272 Technico Constructions Inc.3272 DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Bécaneourt, paroisse.3273 Roxboro.3273 Ste-Monique-des-Saules.3273 Terres et Fouets: Service du Cadastre: Aylmcr, village.3273 Beauport, paroisse.3274 Beauport, paroisse.3274 Stanstead, canton.3274 St-Rémi, village.3274 Examens du Barreau: Abitibi-Témiscamingue, étude.3274 Orders in Council: 748-A \u2014 (îarage employees, regions of Roberval, St-Félicien and Dolbeau 3262 748-B \u2014 Barbering and hairdressing, region of St.Francis.3263 748-C \u2014 Retail food products, region of Quebec.3264 Meeting : Corporal ion de l'Observatoire de Québec 3268 Notice to Interested Parties: 3233 Miscellaneous Notices : Association d'Épargne de Windsor (Foundation).3270 Association des Chauffeurs et Employés de la Compagnie de Transport Montmorency (Formation).3269 La Caisse d'Établissement Rural de la Chaudière (Foundation).3270 La Caisse Populaire Desjardins de Ste-Martlie de Gaspé (Foundation).3270 The Province of Quebec Shoe Retailers Association \u2014 L'Association des Détaillants de la Chaussure du Québec (Formation).3268 L'Institut de Cardiologie de Québec (By-Laws).3271 L'Orchestre Symphonique de Québec (By-Law).3271 Lu-Rich Building Corporation (Dist.of assets).3270 Lu-Rich Building Corporation (By-Law).3271 Nairn Falls Pulp Company Ltd.(Dist.t*a of assets).3269 Nova Dania Home (By-Laws).3270 Rusty Lake Mining Corporation (Directors).3269 Syndicat des Producteurs Fournisseurs de Lait à la Laiterie de Sherbrooke Limitée (U.C.C.) (Formation).3268 Charters \u2014 Surrender of: Chateaufort Inc.3272 City House Furniture Inc;.3272 Lu-Rich Building ('orporation.3272 Safari Inc.3272 Technico Constructions Inc.3272 DEPARTMENTAL N(HTCES: Education: School Municipality of: Bécaneourt, parish.3273 Roxboro.3273 Ste-Monique-des-Saules.3273 Lands and Forest: Cadastral Branch: Aylmer, village.3273 Beauport, parish.3274 Beauport, parish.3274 Stanstead, township.3274 St-Rémi, village.3274 Bar Examinations: Abitibi-Témiscamingue.study.3274 3304 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Qvébec, 15 août 1959, Tome 91, N° S3 Lettres patentes: Addington Realty Corp.3234 Agences Lambert & Bru net Agencies Inc.3235 Allison's Ltd.3235 Artists and Photographers Inc.3235 Beatty Development Corporation.3230 Berne Investment Corp.:.3236 Besson Realties Inc.3236 Cambridge Builders Inc.3237 C.E.Blier & Fils Inc.3237 Centre Récréatif de (iranby Inc.3237 ( lhagram Investments Incorporated.3238 Daniel's Leather Goods Inc.3238 David Realty Corp.3238 Dovex Corp.3239 Ellendale Realty Corp.3239 Elmark Land Development Co.3239 Ernest Carrière (1959) Inc.3240 Exclusive Real Estate Broders Inc.3240 Fast Foundation Forms Limited.3240 Footwear Supply Agencies Ltd.3241 Franklyn Associates Ltd.3241 Garnet Investment Corp.3242 (Jen-Tee Ltd.3242 Helen Land Development Corp-.3242 Jaymour Land Investment Corp.3242 La ( :ie Kébek ( 'onstruct ion Ltée.3243 Ix;s Immeubles L'Assomption Inc.3243 Les Produits Alimentaires Allaire Inc.3243 Ligue de la Jeunesse Catholique.3244 Luzerna Inc.3244 Meed Investments Ltd.3245 Menuiserie Evain Woodwork Inc.3245 Michel Haroon Incorporée.3245 Montdale Realties Inc.3246 Myco Enterprises lue.3246 N.' 1).G.Investments Inc.3246 Ncehe Investment Corp.3247 Nu-Val Construction Ltd.3247 Outremont Heights Ltd.3247 Qucmont Construction Ltd.\u2014 Qucmont Construction Ltée.3247 Raymond Delisle Inc.3248 Raymond Martin Ltée.3248 Riel Investment Corp.3249 Rishon Investment Corp.3249 Saleras Investment Corporation.3249 Sanrube Investment Company.3250 Seaside Realty Corp.3250 Scphan Investment Corp.3250 Sherwood Catering Corporation.3250 Spruccwood Developments Inc.3251 Stekal Investment Corp.3251 Ste.Monique Realty Corp.3252 St.Laurent Stables Co.3252 Sulema Realties Inc.3252 Sun Valley Investment Corporation.3252 Swedco Investment Corp.3253 Thirty-Six Thirty-Seven Development Corporation.3253 Trevi Investment Corp.3253 Vicinity Development Corp.3254 Walter Investment Corp.3254 Welding Products Limited.3254 Westbury Investments Corp.3255 Westmount Gardens Inc.3255 Yorkdale Development Corp.3255 320 Ste Rose Limited.3256 Lettres patentes supplémentaires: Alliance Investment Corporation of Canada.3256 Ballast Iron & Metal Inc.3256 Canadian Stockholders Investment Corporation .3257 Letters Patent: Addington Realty Corp.3234 Agences Lambert & Brunet Agencies I.nr.3235 Allison's Ltd.3235 Artists and Photographers Inc.3235 Beatty Development Corporation.3236 Berne Investment Corp.3236 Besson Realties Inc.3236 Cambridge Builders Inc.3237 C.E.Blier & Fils Inc.3237 Centre Récréatif de Granby Inc.3237 Chagram Investments Incorporated.3238 Daniel's Ix*ather Goods Inc.3238 David Realty Corp.3238 Dovex Corp.3239 Ellendale Realty Corp.3239 Elmark I .and Development Co.3239 Ernest Carrière (1959) Inc.3240 Exclusive Real Estate Broders Inc.3240 Fast Foundation Forms Limited.3240 Footwear Supply Agencies Ltd.3241 Franklyn Associates Ltd.3241 (Jarnet Investment Corp.3242 (Jen-Tec Ltd.3242 Helen Land Development Corp.3242 Jaymour Land Investment Corp.3242 La Cie Kébek Construction Ltée.3243 Les Immeubles L'Assomption Inc.3243 Les Produits Alimentaires Allaire Inc.3243 Ligue de la Jeunesse Catholique.3244 Luzerna Inc.3244 Meed Investments Ltd.3245 Menuiserie Evain Woodwork Inc.3245 Michel Haroon Incorporée.3245 Montdale.Realties Inc.3246 Myco Enterprises Inc.3246 N.D.G.Investments Inc.3246 Neebe Investment Corp.3247 Nu-Val Construction Ltd.3247 Outremont Heights Ltd.3247 Quemont Construction Ltd.\u2014 Qucmont Construction Ltée.3247 Raymond Delisle Inc.3248 Raymond Martin Ltée.3218 Riel Investment Corp.3249 Rishon Investment Corp.3249 Saleras Investment Corporation.3249 Sanrube Investment Company.250 Seaside Realty Corp.3250 Sephan Investment Corp.3250 Sherwood Catering Corporation.3250 Spruccwood Developments Inc.3251 Stekal Investment Corp.3251 Ste.Monique Realty Corp.3252 St.Laurent Stables Co.3252 Sulema Realties Inc.3252 Sun Valley Investment Corporation.1252 Swedco Investment Corp.3253 Thirty-Six Thirty-Seven Development Corporation.3253 Trevi Investment Corp.3253 Vicinity Development Corp.3254 Walter Investment Corp.3254 Welding Products Limited.3254 Westbury Investments Corp.3255 Westmount Gardens Inc.3255 Yorkdale Development Corp.3255 320 Ste Rose Limited.3256 Supplementary Letters Patent: Alliance Investment Corporation of Canada.3256 Ballast Iron & Metal Inc.3256 Canadian Stockholders Investment Corporation.3257 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 15th, 1959, Vol.91, No.33 3305 Coronation Realties Inc.3257 Dimensioned Veneers Inc.3257 Eastern Milk Concentrates Ltd.3257 E.I/compte Draperies Ltée.3258 Km i éprises Ernest ('arrière Ltée.3258 Fernand Lucchesi Ltée.3258 Independent Poultry Farms Ltd.3258 La Maison Bienvenu Limitée.3259 Les [mmeubles Girard Ltée.3259 M el Sewing Machine Company Limited.3259 Maurice Gagné Inc.3259 Montreal Acceptance Corporation.3260 Montréal Diffusion Inc.3260 Morgan & Co.Ltd.3260 Murmont Investments Limited.3260 Roscmère Golf Club Incorporated.3261 The N.A.Timmins Corporated.3261 The New Carlton Limited.3261 Zee Investments Limited.3261 LlQUldation.avis de: Builders & Realtors Limited.3275 Okfick des marchés agricoles du Qi i.iiec: Avis de réception de plan conjoint de m Lie en marché: Le plan conjoint «les Producteurs de Mois de Pulpe de Lévis-Bellechasse.3275 Sièges sociaux: Ernest Carrière (1959) Inc.3276 Gcn-TccLtd.,.3276 Hôpital Longueuil Inc.3277 Les Appartements Berri Apartments Ltée.3275 Librairie Universelle Inc.3276 M.r Enterprises Ltd.3277 Menuiserie Evain Woodwork Inc.3276 Oui remont Heights Ltd.3276 Robert Frenette Inc.3277 The Great Watchichou Company Ltd.3277 Soumissions: acton Vale, ville.3285 Arvida, comm.des écoles cat h.3278 Fabreville, ville.3283 L'Aoord-à-Plouffe, ville.3287 La Malbaie, ville.32S0 Lévis, cité.3281 Sherbrooke, cité.3284 St-Camille, comm.scolaire.3279 Ste-Monique-des-Saules.munie.3288 Ventes, Loi de faillite: Duchesne, Gérard.3290 Maltais, Antonio.3289 Ventes pour taxes: Dolbeau, ville.3291 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi: Garage Central d'Amos Ltée vs Roussy.3292 G( o-Explorers Limited vs Oka-Rathurst Mining Corporation Limited.3292 Coronation Realties Inc.3257 Dimensioned Veneers Inc.3257 Eastern Milk Concentrates Ltd.3257 E.Lccompte Draperies Ltée.3258 Entreprises Ernest Carrière Ltée.3258 Fernand Lucchesi Ltée.3258 Independent Poultry Farms Ltd.3258 La Maison Bienvenu Limitée.3259 Les Immeubles Girard Ltée.3259 Marvel Sewing Machine Company Lim ited.3259 Maurice Gagné Inc.3259 Montreal Acceptance Corporation.3260 MontréalDiffusion Inc.3260 Morgan & Co.Ltd.3260 Murmont Investments Limited.3260 Roscmère Golf Club Incorporated.3261 The N.A.Timmins Corporated.3261 'Hic New Carlton Limited.3261 Zee Investments Limited.3261 Winding up Notices: Builders & Realtors Limited.3275 Quebec Agriculture Marketing Board: Notice of reception of joint marketing plan: The Lévis-Bellechasse Pulpwood Producers joint plan.3275 Head Offices: Ernest Carrière (1959) Inc.3276 Gen-Tec Ltd.3276 Hôpital Longueuil Inc.3277 Les Appartements Berri Apartments Ltée.3275 Librairie Universelle Inc.3276 Mayer Enterprises Ltd.3277 Menuiserie Evain Woodwork Ine.3276 Outremont Heights Ltd.3276 Robert Frenette Inc.3277 The Great Watchichou Company Ltd.3277 Tenders: Acton Vale, town.3285 Arvida, Cath.school comm.3278 Fabreville, town.3283 L'Abord-à-Plouffe.town.3287 La Malbaie, town.3280 Levis, city.3281 Sherbrooke, city.3284 St-Camillc, school comm.3279 Ste-Monique-des-Saules, munie.3288 Sales, Bankruptcy Act: Duchesne, Gérard.3290 Maltais, Antonio.3289 Sales for Taxes: Dolbeau, town.3291 SHERIFFS' SALES: Abitibi: Garage Central d'Amos Ltée vs Roussy.3292 Gco-Explorers Limited vs Oka-Batburst Mining Corporation Limited.3292 3306 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 15 août 1959, Tome 91, N° 33 Beauce: La Loi de l'Impôt sur le Revenu vs Quirion.3293 United Loan Corporation vs Bédard.3293 Beauharnois: Arthur Couillard Ltée vs Rioux et al.3293 Gaspé: Gaudreau et al vs Amiot.3294 Hull: Lefebvre vs Roussel et al.3294 Ménard vs Gem Construction.3295 Joliette: Canada Life Assurance Company vs Trottier.3295 Frechette vs Rocheleau et al.3296 Kamouraska: Alphonse Raymond Limitée vs Gagnon.3297 Langlais vs Boucher.3298 Poulin vs Courcy.3298 Montréal: Cohen vs Doré.3300 Henderson vs Rayner ctvir.3299 Interprovincial Building Credits Ltd vs Vigncault.3299 Vincent vs Laflamme etvir.3298 Richelieu: Déguise vs Richelieu Steel & Metal Co.3300 Routn-Noranda: Champlain Oil Products Limited vs Beaudoin.3301 Saint-François: Jean-Paul Perreault Ltée vs Saine.3301 L'Office du Crédit Agricole du Québec vs Couture.3302 Beauce: The Income Tax Act vs Quirion.3293 United Loan Corporation vs Bédard.3293 Beauharnois: Arthur Couillard Ltée vs Rioux et al 3293 Gaspé: Gaudreau et al vs Amiot.3294 Hull: Lefebvre vs Roussel et al.3294 Ménard vs Gem Construction.3295 Joliette: Canada Life Assurance Company v Trottier.3295 Frechette vs Rocheleau et al.3296 Kamouraska: Alphonse Raymond Limitée vs Gagnon.3297 Langlais vs Boucher.3298 Poulin vs Courcy.3298 Montreal: Cohen vs Doré.3300 Henderson vs Rayner etvir.3299 Interprovincial Building Credits Ltd vs Vigneault.3299 Vincent vs Laflamme etvir.3298 Richelieu: Déguise vs Richelieu Steel & Metal Co.3300 rou yn-nor an d a : Champlain Oil Products Limited vs Beaudoin.3301 Saint Francis: Jean Paul Perreault Ltée vs Saine.>301 Quebec Farm Credit Bureau vs Couture.3302 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine Quebec:\u2014 Printed by Rédempti Paradis.Queen's Printer."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.