Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 19 (no 38)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1959-09-19, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tomb 91, \\° v38 3689 Vol.91, No.38 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 19 septembre 1959 - AVIS AUX INTERESSES Règlements 13 Adresser foute correspondance à: l'Imprimeur de lu Reine.Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de 1 Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s il y a lieu, toute somme' versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle île Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC QueIbec, Saturday, September 19th, 1959 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to he published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queens Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa* classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3690 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° 38 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Eeuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec.27 juin 1940.41502- l-52-o receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last day.-: of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition., Moreover the Queen's Printer is entil led to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administra^ tion.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion', the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates.Subscriptions, etc.Eirst insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate; Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: S7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th.1940.41502 \u2014 l-52-o Lettres patentes Letters patent (P.G.13196-59) Alamac Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 1959, constituant en corporation: Giora Bloomstone, ingénieur civil, Seymour Machlovitch et Morris Chaikelson, avocats, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, 'sous le nom de \"Alanine Realty Corp.\", avec un capital total de $4,000, divisé en 4,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire, de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51171 P.FRENETTE.(A.G.13196-59) Alamac Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, bearing date the fourth day of June, 1959, incorporating: Giora Bloom-stone, civil engineer.Seymour Machlovitch and Morris Chaikelson, advocates, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a realty company, under the name of \"Alamac Realty Corp.\".with a total capital stock of S 1.000.divided into 4,000 shares of SI each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June.1959.P.FRENETTE, 5147l-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th.1959, Vol.91, No.88 3691 (P.G.13478-59) Alfred Holding Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I/>i des compagnies de Quél>ec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1959, constituant en corporation : Albert Marcus, Abraham Fciner, et Isidore Reuben PrazofF, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Alfred Holding Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune, 1,000 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de SI chacune et 80 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur ¦ ni pair de $100 chacune.Ix! siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.ERENETTE.(P.G.13124-59) Atomic Paint Works Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mai 1959, constituant en corporation: Mario Beaulieu, Domenic Manzo, notaires, et Pilippo Zunini, stagiaire, tous de St-Zotique-Est, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, de construction et de matériaux employés en celle-ci, sous le nom de \"Atomic Paint Works Inc.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 2,000 actions communes de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.ERENETTE.(P.G.13503-59) Attractions Touristiques Laurcntiemies Inc.\u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize juin 1959, constituant en corporation: Guy Piché, Ernest Piché, commerçants, et Madeleine Longpré, ménagère, épouse commune en biens dudit Ernest Piché, tous de Ste-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: Exercer le commerce de transport de voyageurs sur le Lac-des-Sables, à Ste-Agathe-dcs-Monts, district de Terrebonne, et celui de fournir des attractions et accommodations pour touristes, sous le nom de \"Attractions Touristiques Laurcntiemies Inc.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saintc-Agathe-dcs-Monts, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le seize juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.ERENETTE.(AG.13478-59) Alfred Holding Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1959, incorporating: Albert Marcus, Abraham Eciner and Isidore Reuben Prazoff, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of an investment, company, under the name of \"Alfred Holding Corp.\", with a total capital stock of S10,000, divided into 100 common shares of a par value of 810 each, 1,000 preferred shares class \"A\" of a par value of $1 each and 80 preferred shares class \"B\" of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1959.P.ERENETTE, 5147l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13124-59) Atomic Paint Works Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of May, 1959, incorporating: Mario Bcaulicu, Domenic Manzo, notaries, and Filippo Zunini.law clerk, all of St.Zotique-East, for the following purposes: To deal in immoveables, building operations and materials used therein, under the name of \"Atomic Paint Works Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of S10 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13563-59) Attractions Touristiques Laurcntiemies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of June, 1959, incorporating: Guy Piché, Ernest Piché, tradesmen, and Madeleine Long-pré, housewife, wife common as to property of the said Ernest Piché, all of Stc-Agathe-des-Monts, for the following purposes: To operate a business for the transportation of travellers on Lac-des-Sables, to Ste-Agathe-dcs-Monts, district of Terrebonne, and that of supplying attractions and accommodations for tourits under the name of \"Attractions Touristiques Laurentiennes Inc.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 200 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Sainte-Agathe-dcs-Monts.judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General. 3692 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, ;V° 38 (P.G.13344-59) Austria Bakery Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 1959, constituant en corporation: Anton Càillicit.Frank Martin boulangers et Koethe Martin, ménagère, épouse sépar'e de biens dudit Frank Martin, mariée, en vertu des lois d'Autriche, tous de Montréal, pour les objets suivants: Cuire, boulanger, acheter, vendre ou autrement faire le commerce du pain, pâtisserie et autres produits alimentaires et acquérir des terrains et constructions à des fins commerciales ou de placements, sous le nom de \"Austria Bakery Limited\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 81 (X) chacune.Le siège social de la compagnie sera 9995 avenue Laurentide Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.11271-59) Bellérive Bowling Ine.Avis est donné «m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1959, constituant en corporation: Eugène Bourcier, entrepreneur-constructeur, Aline Taillefcr Bourcier, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Eugène Bourcier, et Joseph Bourcier, agent, tous de Valleyfield, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fournir de l'amusement au publie, et sans limiter la généralité de ce qui précède, exploiter des salles de quilles, de billard, et autres places d'amusement, sous le nom de \"Bellérive Bowling Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions communes d'une valeur au pair de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.IiC siège social de la compagnie sera à Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(P.G.13501-59) Benmar Hosiery Mills Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1959, constituant en corporation: Aaron Liebcrman, marchand.Shirley Simon et Claude Morin, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, importer et exporter, acheter et vendre tant au gros qu'au détail, et agir comme négociants d'aucune et toutes sortes et descriptions de bas pour dames, bas de soie et nylon, sous le nom de \"Benmar Hosiery Mills Ltd.\", avec un capital total de 8-10,000, divisé en 10.000 actions ordinaires de 81 chacune et 30.000 actions privilégiées de 81 chacune.(A.G.13344-59) Austria Bakery Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent haw-been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, bearing date the fourth day of June, 1959, incorporating: Anton Gillich, Frank Martin, bakers, and Koethe Martin, housewife, wife of the above Frank Martin, married under the law of Austria, all of Montreal, for the following purposes: To bake, manufacture, purchase, sell or deal otherwise in bread, confectionery and other fond stuff and to acquire land and buildings for business purposes or investment purposes, under the name of \"Austria Bakery Limited\", with a total capital stock of 840.000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 9W~) Laurentide Avenue, Montreal, judicial district ol Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1959.P.FRENETTE, 5147 l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11271-59) Bellcrivc Bowling Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1959, incorporating: Eugène Bourcier, building contractor.Aline Taillefcr Bourcier, housewife, wife contractually separate as to property of the said Eugène Bourcier, and Joseph Bourcier, agent, all of Valleyfield, for the following purposes: To carry on the business of providing the public with amusements, and without limiting the generality of the foregoing, operate bowling alleys, pool-roôms and other places of amusement, under the name of \"Bellérive Bowling Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a par value of 810 each and 2,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be ;it Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(a.g.13501-59) Benmar Hosiery Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June.1959, incorporating: Aaron Liebcrman, merchant, Shirley Simon and Claude Morin, secretaries, filles majeures, all of Mont real, for the following purposes: To manufacture, import and export, buy and sell, both wholesale and retail, and to act as jobbers of ladies' silk and nylon stockings and ladies' stockings of any and all kinds and descriptions, under the name of \"Benmar Hosiery Mills Ltd.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 10,000 common shares of 81 each and 30,000 preferred shares of 81 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.88 3693 Le siège social de la compagnie sera 3453 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1959.L Assistant-procureur général suppléant.,1471 P.FRENETTE.P.G.13319-59) Rob Lunny Sporting Goods Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juin 1959, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Nathaniel Licbnian.notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, trafiquer et autrement faire le commerce, négocier en marchandises de sport, vêtements et équipement de sport de toutes sortes, sous le nom de \"Rob Lunny Sporting Goods Ltd.\", avec un capital total de $40,000.divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de SI0 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ment réal.district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1959.L Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.The head office of the company will Ik; at 3453 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June.1959.P.FRENETTE, 51471 -o Acting 1 )eputy Attorney ( Jeneral.(A.G.13319-59) Bob Lunny Sporting Goods Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 tot the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor'of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1959, incorporating: Abraham Sinister, advocate.Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, law student, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture, trade and otherwise deal in and with sporting goods, sports clothing and sporting equipment of all kinds, under the name of \"Bob Lunny Sporting Goods Ltd.\".with a total capital stock of $40.000.divided iiito 500 common shares of $10 each and 3.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of June.1959.P.FRENETTE.51471-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13382-59) Boutin Transport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente juin 1959, constituant en corporation: Dominique Boutin, Jean-Marie Gagnon, camionneurs.Léo Vanasse, garagiste, tous trois de Iai Sarre, et Victorin Veillettc, marchand, de Sce-Ilélène-dc-Manccbourg.pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de passagers et de marchandises de toutes sortes, sous le nom de \"Boutin Transport Ltée\", avec un capital total de $75.000, divisé en 15.000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le trente juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(A.G.13382-59) Boutin Transport Ltée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-( Jovernor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of June, 1959, incorporating: Dominique Boutin, Jean-Marie Gagnon, truckers, v Léo Vanasse, garage-keeper, all three of La Sarre, and Victorin VeiMette, merchant, of Ste-Ilélène-de-Manccbourg, for the following purposes! To operate a business for the transportation of passengers and merchandise of all kinds, under the name of \"Boutin Transport Ltée\", with a total capital stock of $75.000.divided into 15,000 shares of $5 each.The head office of the company will be at La Sarre.judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12710-59) Brompton Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1959, constituant en corporation: Edgar Boucher, gérant des achats.Vvctte Lecours Boucher, ménagère, épouse commune en biens dudit Edgar Boucher, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Bromptonville, Raymond Bergeron, commerçant, et Rita Bélanger Bergeron, ménagère, épouse séparée de biens dudit Raymond Begeron, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Sherbrooke, pour les objets suivants: (A.G.12710-59) Brompton Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the LieutenanM Jovernor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June.1959, incorporating: Edgar Boucher, purchasing manager, Yvette Lecours Boucher, housewife, wife common as to property of the said Edgar Boucher, and duly authorized by him for the purposes therein, both of Bromptonville, Raymond Bergeron, dealer, and Rita Bélanger Bergeron, housewife, wife separate as to property of the said Raymond Bergeron, and duly authorized by him for the purposes therein, both of Sherbrooke, for the following purposes: 3694 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° 38 Commerce d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Brompton Construction Inc.'.avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de §100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Bromp-tonvilie, district judiciaire de Saint-Francois.Daté du bureau du Procureur général, le douze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 ~ P.FRENETTE.The real estate and construction business, under the name of ,fcBrompton Construction Inc.\", with a total capital stock of §40,000.divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Bromptonville, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13712-59) Canabo Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première ' partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1959, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, avocat, d'Outremont, Micheline Corbeil, avocate, Françoise Constant, secrétaire, toutes deux célibataires.Roger Girard, comptable agréé, tous trois de Montréal, et Ghislaine Gagné, secrétaire, célibataire, de Laval-des-Rapides, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Canabo Inc.\", avec un capital total de $50.000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.IiC siège social de la compagnie sera 1504, rue Davidson, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(P.G, 13679-59) Canadian Tire & Repair (I.a Tuque) Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1959, constituant en corporation: J.-Elzéar Turcotte, de Charlesbourg, Roland Gagnbn, de St-Félicicn, tous deux industriels, et J.-Émilien Simard, avocat et conseil en loi de la Reine, de Sillery, pour les objets suivants: Exercer le commerce de garagistes, sous le nom de \"Canadian Tire & Repair (La Tuque) Co.Ltd.\", avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ïm Tuque, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.FRENETTE.(P.G.13514-59) Canoru Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quélxc des lettres patentes, en date du \"onze juin 1959, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, avocats et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objers suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le (A.G.13712-59) Canabo Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quelle Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, 1959, incorporating: Henri Paul Lemay, advocate, of Outremont, Micheline Corbeil.advocate, Françoise Constant, sécrétai y, both spinsters, Roger Girard, chartered accountant, all three of Montreal, and Ghislaine Gagné, secretary, spinster, of Laval-des-Rapides, for the following purposes: To carry on the operations of an investment and holding company, under the name of \"Canabo Inc.\", with a total capital stock of $50.000.divided into 5.000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1504 Davidson Street, Montreal, judicial district of M out teal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of June.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13679-59) Canadian Tire & Repair (La Tuque) Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of June, 1959, incorporating: J.-Elzéar Turcotte, of Charlesbourg, Roland Gagnon, of St-Eélicien, both industrialists and J.-Émilien Simard, advocate and Queen's Counsel, of Sillery, for the following purposes: To operate a business as garage-keepers, under the name of \"Canadian Tire & Repair (La Tuque) Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at La Tuque, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of June, 1959.P.ERENETTE.51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13514-59) Canora Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1959, incorporating: Seymour Machlovitch, Moi ris Chaikelson, advocates, and Nicole Paternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a reai estate, development and construction company, under the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.38 3695 nom de \"Canora Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé én 5.000 actions île $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 9720 rue Jeanne Mance.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.(P.G.13748-59) Centre des Jeunesses Musicales du Canada à Montréal Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq juin 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Papineau-Couture, musicien, d'Outremont, Serge Carreau, étudiant, \u2022 le Marieville, et Claire Grégoire, étudiante, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Travailler au développement de la culture musicale et artistique de la jeunesse de la région «le Montréal, sous le nom de \"('entre des Jeunesses Musicales du Canada à Montréal\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $ 15,000.Le siège social de la corporation sera 3425, rue St-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(P.G.13340-59) Chong Wah Noodle Manufacturing Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du premier juin 1959, constituant en corporation: Harry J.Erdrich, Michael Rubinstein, tous deux de Montréal, et Alex Raider, de la ville Côte St-Luc, tous avocats, pour les objets suivants: Moudre, acheter, vendre et faire le commerce de farines, moulées .et tous produits alimentaires provenant de grains, ou céréales, sous le nom de \"Chong Wah Noodle Manufacturing Company Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 7,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.11673-59) Club Nautique du Lac Cimon Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1959, constituant en corporation name of \"Canora Development Corp.\", with a total capital stock of $5.000.divided into 5,000, shares of $1 each.The head office of the company will l>e at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13748-59) Centre des Jeunesses Musicales du Canada à Montréal Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of June, 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Jean Papineau-Couture, musician, of Outremont, Serge Carreau, student, of Marieville.and Claire Grégoire, student, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To further the musical and artistic* development and culture of the youth of the Montreal Region, under the name of \"Centre des Jeunesses Musiealesdu Canada à Montréal\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $15,000.The head office of the corporation will be at 3425 St.Denis Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13346-59) Chong Wah Noodle Manufacturing Company Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of June, 1959, incorporating: Harry J.Erdrich, Michael Rubinstein, both of Montreal, and Alex Raider, of the town of Côte St.Luc, all advocates, for the following purposes: To manufacture, buy, sell and deal in .'iours, meals and all food articles manufactured from grains or cereals, under the name of \"Chong Wah Noodle Manufacturing Company Inc.\", with a total capital stock of $100,000.divided into 7,500 common shares of a par value of $10 each and 2,500^ preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11673-59) Club Nautique du Lac Cimon Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June.1959.to incorporate as a corpora- 3690 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.19 septembre 1959, Tome 91, N° 38 Sans capital-actions: Paul-A.Marion, représentant, Jean-Paul Forest, secrétaires, tous deux de Montréal, et George Hutton, garagiste, de St-Michel, pour les objets suivants: Promouvoir et organiser tout sport, loisir et concours, à l'exclusion de ceux défendus par la loi, sous le nom de \"Club Nautique du Lac Cimon\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8100,000.Le siège social de la corporation sera à Chéné-ville, comté de Papineau, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.tion without share capital: Paul-A.Marion, agent, Jean-Paul Forest, secretary, both of Montreal, and George Hutton, garage-keeper, of .St.Michel, for the following purposes: Promote and organize any sport, recreational activity and contest, save those forbidden by law, under the name of \"Club Nautique «lu Lac Cimon\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8100,000.The head office «>f the corporation will be at Chénéville, county of Papineau.judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of June.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.10801-59) Coaticook Finance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1959, constituant en corporation: Marguerite Forticr, Simonne Bouchard.secrétaires, et Paul Gérin, avocat, tous de Coaticook, pour les objets suivants: Exercer le commerce général «le préteur «l'argent dans toutes et chacune «le ses spécialités, sous le nom «le \"Coaticook Finance Inc.\".avec un capital total de 8225,000.divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et en 2.000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 47, rue Child, Coaticook, district judiciaire «le Saint-François.Daté du bureau «lu Procureur général, le onze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471-0 P.FRENETTE.(P.C.13551-59) Corporation Bienvenu Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en «late du quinze juin 1959, constituant en corporation: Christophe-Antoine Geoffrion, «le Westmount, Guillaume Geoffrion, Raymond-Gervais Décary.Fernand Lalonde et Réjane Laberge Colas, épouse séparée «le biens d'Emile Colas, tous quatre «le Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, sous le nom de \"Corporation Bienvenu\", avec un capital total de 810.000, divisé en 10,000 actions d'une valeur au pair de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1959.L'Assistant-procureur généra] suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13594-59) Delnor Development Inc.Avis est donné «pi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date (A.G.10801-59) Coaticook Finance Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the eleventh day of June.1959, incorporating: Marguerite Forticr, Simonne Bouchard, secretaries, and Paul Gérin, advocate, all of Coaticook, for the following purposes: To carry on a business generally as a moneylender in all and each of its specialties, under the name of \"Coaticook Finance Inc.\", with a total capital stock of $225,000.divided into 250 common shares of $100 each and into 2,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 47 Child Street.Coaticook, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney (.encrai.(A.G.13551-59) Corporation Bienvenu Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth «lay of June, 1959, incorporating: Christophe-Antoine Geoffrion, of Westmount.Guillaume Geoffrion, Raymond-Gervais Décary.Fernand Lalonde and Réjane Laberge Colas, wife separate as to property of Emile Colas, all four of Montreal, all advocates, for the following purposes : # To carry on the business of an investment company, under the name of \"Corporation Bienvenu\", with a total capital stock of 810,000,divi-ded into 10.000 shares of a par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dateil at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of June.1959.P.FRENETTE.51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13594-59) Delnor Development hie.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governorfof the Province of Quebec, bearing date the fifteenth QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.38 3697 \u2022 in quinze juin 1959, constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en l/oi, de Ville Mont-Koyal, Ernest William Mockridge, gérant, de St-Lambcrt, Clifford George Meek, de .Montréal, et Guy Ambrose Miller, de St-Bruno.tous deux teneurs de livres, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, immeubles, construction et développement général, sous le nom de \"Delnor Development Inc.\", avec un capital total de §10,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du \" bureau du Procureur général, le quinze juin 1959; ' L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13117-59) Deviro Development Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la ïx>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq juin 1959, constituant en corporation: Daniel Kingstone, Samuel Godinsky, avocats, et Katherine Ingledew, sténographe, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Deviro Development Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 900 actions privilégiées, d'une valeur au pair de $10 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de \u2022S 10 chacune.\\jC siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du' bureau du Procureur général.le cinq juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 \u2022 P.FRENETTE.day of June, 1959, incorporating: William Patrick Creagh, Law clerk, of the Town of Mount Royal, Ernest William Mockridge, manager, of St.Lambert.Clifford George Meek, of Montreal, and Guy Ambrose Miller, of St.Bruno, both bookkeepers, for the following purposes: ' To carry on the business of a land, real estate, construction and general development company, under the name of \"Delnor Development Inc.\", with a total capital stock of §10,000, divided into 1,000 shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district oT Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of .lune, 1959.P.FRENETTE.51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13417-59) Deviro Development Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1959.incorporating: Daniel Kingstone, Samuel Godinsky, advocates, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Deviro Development Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 900 preferred shares having a par value of $10 each and 100 common shares having a par value of $10each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of June, 1959.P.ERENETTE.51471-0 Acting Deputy Attorney Genera).P.G.14097-59) Drummond Seat Cover Center Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juillet 1959, constituant en corporation: Marcel Roy, Jack Desmarais, vendeurs, et Hervé Desmarais, garagiste, tous de Drummondville, pour les objets suivants: Exercer le commerce consistant en la réparation et l'entretien d'intérieurs d'automobiles et de véhicules de toutes sortes, sous le nom de \"Drummond Seat Cover Center Ltd.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de §100 chacune et en 2.500 actions ordinaires d'une valeur au pair de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drummondville, .district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le dix juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471-o P.FRENETTE.(P.G.13449-59) Duvalco Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.14097-59) Drummond Seat Cover Center Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of July, 1959, incorporating: Marcel Roy.Jack Desmarais, salesmen, ami Hervé Desmarais, garage-keeper, all of Drummondville.for the following purposes: To operate a business consisting in the reparation and maintenance of the interior of automobiles and of vehicles of all kinds, under the name of \"Drummond Seat Cover Center Ltd.\", with a total capital stock of §40.000.divided into 150 preferred shares of a par value of §100 each and into 2.500 common shares of a par value of §10 each.The head office of the company will be at Drummondville.judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of July, 1959.P.FRENETTE.51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13449-59) Duvalco Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that iindei Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have 3098 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 19 septembre 19Ô9, Tome 91, A'0 38 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du huit juin 1959, constituant en corporation: Edward S.Berger, avocat, Shirley Simon, Claude Morin, et Ellen Haggenmueller, toutes trois secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Duvalco Realty Co.Ltd.\".avec un capital total de 840,000, divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de Ja compagnie sera a Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13951-59) Édifice Charette Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi ties compagnies de Québec, il a été' accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du deux juillet 1959, constituant en corporation: François Francoeur, Raymond Boucher, tous deux avocats, et Thérèse de Margerie, traductrice, célibataire, tous de Sept-Ues, pour les objets suivants: Commerce d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Edifice Charette Limit 'e\", avec un capital divisé en 400 actions sans valeur au pair ou nominale, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est «le $2,000.- Le siège social «le la compagnie sera 459, rue Brochu, Sept-Iles, district judiciaire «le Saguenay.* Daté du bureau «lu Procureur général, le deux juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.FRENETTE.(P.G.12581-59) Fabrique Nationale de Monte-Pentes et Téléphériques Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en «late du douze juin 1959, constituant en corporation: Paul (iélinas, avocat, Claire Loiscau, secrétaire, et Pâquerette Bourret Beaudoin, secrétaire, épouse judiciairement séparée de corps et de biens de J.-Noël Beaudoin, tous de Ste-Agathe-' des-Monts, pour les objets suivants: Industrie et commerce de monte-pente et «le tramways aériens, sous le nom de \"Fabrique Nationale de Monte-Pentes et Téléphériques Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions communes de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jovite, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau «lu Procureur général, le douze juin 1959.L Assistant-procureur général suppléant, 51471 -o P.FRENETTE.(P.G.13502-59) t Foothill Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of June, 1959.incorporating: Edward S.Berger, advocate, Shirley Simon, Claude Morin an«l Ellen Haggenmueller.all three secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Duvalco Realty Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of June.1959.P.ERENETTE, 5147 l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13951-59) .Edifice Charette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July.1959, incorporating: François Francoeur, Raymond Boucher, both advocates, and Thérèse «le Margerie, translator, spinster, all of Sept-Iles, for the following purposes: The real estate and construction business under the name of \"Édifice Charette Limitée\", with a capital stock divided into 400 shares without nominal or par value, and the amount with which the company shall commence its operations, is $2,000.The head office of the company will be at 459 Brochu Street, Sept-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this second -dav of July, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12581-59) Fabrique Nationale de Monte-Pentes et Téléphériques Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June.1959.incorporating: Paul Gélinas.advocate, Claire Loiseau, secretary, and Pâquerette Bourret Beaudoin, secretary, wife legally separate as to bed and board of J.-Noel Beaudoin, all of Ste.Agathc-des-Monts, for the following purposes: To carry on the business of and deal in ski-lifts and overhead tramways, under the name of \"Fabrique Nationale de Monte-Pentes et Téléphériques Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided int«> 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jovite, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13502-59) Foothill Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 19Ô9, Vol.91.No.38 3699 .'\u2022té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quélwc des lettres patentes, en date du onze juin 1959.constituant en corporation: Albert Goml>erg, avocat, Lewis Goniberg, agent .{'immeubles, et Joseph Altenhaus, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Foothill Investments Ltd.\", avec un capital total de $40.000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 132 ouest, nie St-Jacques.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.1471 P.FltENETTE.(P.G.12523-59) General Automatic Laundry Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des letties patentes, en date du premier juin 1959, constituant en corporation: Daniel Kingstone.Samuel Godinsky, avocats, et Katherine Ingledew, sténographe, célibataire, ious de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, acheter, vendre, importer, exporter, louer et prendre à louage des appareils automatiques «le buanderie et autres machines automatiques pour la vente, sous le nom de \"General Automatic Laundry Co.Inc.\".avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le premier juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.M471 P.FRENKTTK.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1959, incorporating: Albert Goniberg, advocate, Lewis Gomberg, realtor, and Joseph Altenhaus, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Foothill Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 1.000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 132 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June.1959.P.FRENETTE, 51471-p Acting Deputy Attorney General.(A.G.12523-59) General Automatic Laundry Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the first day of June, 1959.incorporating: Daniel Kingstone, Samuel Godinsky, advocates, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster, all «>f Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy, sell, import, export, lease and hire automatic laundry equipment and other automatic vending machines, under the name of \"General Automatic Laundry Co.Inc.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of June.1959.P.FRENETTE.5147 l-o Acting Deputy Attorney General: (P.G.12912-59) Grant's Concrete Products Incorporated Les Produits de Béton Grant Incorporé Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du huit juin 1959, constituant en corporation: Damian Grant, homme «l'affairés, de Douglas-town, Lome .Grant, agent industriel et Bert Briand, comptable agréé, tous deux «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands, fabricants, et vendeurs «le tontes sortes de matériaux de construction et produits de construction dans lesquels le ciment, le béton, la brique et la pierre sont des parties constituantes, sous le nom de \"Grant's Concrete Products Incorporatef the company will be at Clermont, judicial «listrict of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51171 Acting Deputy Attorney General. 3706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1969, Tome 91.JVC 38 (P.G.13784-59) Les Immeubles c.J.L.K.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf juin 1959.constituant en corporation: Jacques LaRoehe, impressario, de Sillery, Odilou Crcvier, industriel, et Raymond LaRoche, comptable agréé, tous deux de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et faire affaires comme constructeurs et eut repreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Immeubles ('.J.L.R.Inc.\", avec un capital total de 8100,000.divisé en 7.500 actions communes de 810 chacune et en 2.500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1300.boulevard Laurier, Québec district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(P.G.13137-59) lies Immeubles Lachapelle Ltée Avis est donné qu'en vertu de la piemière partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juillet 1959, constituant en corporation: Aimand Lachapelle, courtier en immeubles, Lucie Grandchamp, ménagère, épouse séparée de biens dudit Armand Lachapelle, tous deux de Montréal, et Albert Lachapelle, soudeur, de Lachenaie, pour les objets suivants: Commerce d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Les Immcubies Lachapelle Ltée\", avec un capital total de 840.000.divisé en 100 actions communes de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.ERENETTE.(P.G.13782-59) Les Jardins Napierville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-neuf juin 1959, constituant en corporation: Raymond Lachapelle, avocat, Bernade Charette et Huguétte Lessard, secrétaires, célibataires, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et «le cons-truction, sous le nom «le \"Les Jardins Napierville Inc.\", avec un capital total «le 810,000, divisé en 500 actions communes de 810 chacune et en 500 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juin 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(A.G.13784-59) lies Immeubles c.J.L.R.Inc.Notice is hereby given that un«l« r Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1959.incorporating: Jacques LaRoche, impressario, of Sillery.Odilon Crevier, industrialist, ami Raymond LaRoche, chartered accountant, both of Chicoutimi.for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate and to operate as builders and general building contractors, under the name of \"Les Immeubles C.J.L.R.Inc.\".with a total capital stock of 8100,000, divided into 7.500 common shares of 810 each and into 2.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1300 Laurier Boulevard, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of dune.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13137-59) lies Immeubles Lachapelle Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.hitters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the seventh day of July.1959, incorporating: Armand Lachapelle, real estate broker.Lucie Grandchamp, housewife, wife separate as to property of the said Armand Lachapelle, both of Montreal, and Albert Lachapelle, welder, of Lachenaie, for the following purposes: The business of real estate ami building, under the name of \"Les Immeubles Lachapelle Ltée\", with a total capital stock of 840,000.divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of Jul v.1959.P.FRENETTE.51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13782-59) Les'Jardins Napierville Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the.Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of June, 1959, incorporating: Raymond Lachapelle, advocate, Bernadc Charette and Huguettc Lessard, secretraies, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate and construction under the name of \"Les Jardins Napierville Inc.\", with a total capital stock of 810,000.divided into 500 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $10 each.The head office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of June.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec September 19th, 1959, Vol.Ul.No.SS 3707 Les I/oisirs de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke Avis est donné qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi des évêques catholiques romains, 14 George VI.chapitre 70, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date $100 chacune et en 300 actions provilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 93, rue Fusey, Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire de Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le deux juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.Les Loisirs de la Paroisse Saint-Jean-Rapt iste de Sherbrooke Notice is given that under the provisions of section 20 of the Roman Catholic- Bishops Act, 14 George VI, chapter 70, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, under date of the eighteenth day of August, 1959, incorporating \"Les Loisirs de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke\".The head office of the abovementioned corporation is situated in the city of Sherbrooke.Given at the office of the Provincial Secretary, the fourteenth dav of September, 1959.RAYMOND DOUVILLE, 51503 Assistant Secretary of the Province.(A.G.13954-59) IiOranger Electrique Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of July, 1959, incorporating: Jean Perron, advocate.Jacques R.Langevin, chartered accountant, both of Trois-Rivières, and Marie Ange Doyon, secretary, spinster of lull age of majority, of Cap-de-la-Madeleine, for the following purposes: To deal in radio and televisions sets, electrical appliances, musical instruments, furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Loranger Electrique Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will l>e at 93 Fusey Street, Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivires.Dated at the office of the Attorney General, this second day of July, 1959.P.ERENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13491-59) Mimosa Investments Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1959, constituant en corporation: Perry Meyer, de Montréal, Ilyman Solomon, de Aille Mont-Royal, et Louis Feigenbaum, de St-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Mimosa Investments Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.(P.G.13937-59) Morin Mining Exploration Ltd.(Libre de Responsabilité Personnelle) Avis est donné qu en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec (A.G.13491-59) Mimosa Investments Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1959, incorporating: Perry Meyer, of Montreal, Ilyman Solomon, of the town of Mount Royal, ami Louis Feigenbaum, of St.Laurent, all attorneys, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Mimosa Investments Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head oflicc of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the olfice of the Attorney General, this eleventh day of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13937-59) Morin Mining Exploration Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Alining Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant- 3708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 .septembre 19Ô9, Tome 91, N° 38 «les lettres patentes, en date du deux juillet 1959, constituant en corporation: J.-E.Fernando Morin, industriel, de Lauzon, Félix Saulnier.prospecteur, et J.-Raoul Bérubé, courtier en assurance, tous deux de Québec, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, .sous le nom de \"Morin Mining Exploration Ltd.\" (Libre de Responsabilité Personnelle), avec un capital total «le $3,000.000, divisé en 3,000,000 actions communes de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix «pi ils auront payé ou convenu «le payer à la compagnie pour leurs actions.Le sii>ge social «le la compagnie sera Edifice (\u2022ranger & Frère, 210.boulevard Crémazie, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le deux juillet 1050.L Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.FRENETTE.Governor of the Province of Quebec bearing date the second day of July, 1959, incorporating: J.-E.Fernando Morin, industrialist, of Lauzon, Félix Saulnier, prospector, ami J.-Raoul Bérubé, insurance broker, both of Quebec, for the fol-« lowing purposes: To prospect ami explore for mines ami minerals and deal with same, under the name of \"Morin Mining Exploration Ltd.\", (No Personal Liability), with a total capital stock of $3.000.000.divided into 3.000,000 common shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Granger & Frère Building, 210 Crémazie Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of July, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13023-59) Mutual Lan«l Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la I/>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres patentes, en «late du dix-sept juin 1959, constituant en corporation: Paul-Eugène Verreault, industriel.Madeleine Barry Verreault.ménagère, épouse, séparée de biens dudit Paul-Eugène Verreault, et dûment autorisée aux fins des présentes, tous deux de Ste-Foy, et Mlle Louisette Martel, secrétaire, «le Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Mutual Land Corporation\", avec un capital total de $40.000.divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1055, rue d'Assise, Québec, district judiciaire «le Québec.Daté «lu bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471-n P.FRENETTE.(P.G.13499-59) Nadniar Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la l/ii «les compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres patentes, en date «lu dix juin 1959, constituant en corporation: Gregory Sharlap, Max Slapack «4 Arthur Shul-man, tous avocats, «le Montréal, poui les objets suivants: Exercer le commerce général de courtiers d'immeubles et agents à commission, sous le nom «le \"Nathnar Corp.\", avec un capital total de $2,000, divisé en 500 actions ordinaires de $1 chacune et 1.500 actions privilégiées de $1 chacune.Ix' siège social «le la compagnie sera à chambre 415.1010 ouest, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(A.G.13023-59) Mutual Land Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the seventeenth day of June, 1959, incorporating: Paul-Eugène Verreault, industrialist.Madeleine Barry Verreault, housewife, wife separate as to property of the said Paul-Eugène Verreault, and duly authorized for these present purposes, both of Ste-Foy, and Miss Louisette Martel, secretary, of Quebec, for the following purposes: To operate a business dealing irr real estate, under the name of \"Mutual Land Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares «>f $100 each.The bead office of the company will be at 1 ().\">.\"> d'Assise Street.Quebec, judicial «listrict of Qu< bee.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of June, 1959.P.FRENETTE.51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13499-59) \\aclmar Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, bearing «late the tenth day of June.1959, incorporating: Gregory Chariap.Max Slapack and Arthur Shulrnan, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business generally as real estate brokers and commission agents, under the name of \"Nadniar Corp.\", with a total capital stock ol $2,000.divided into 500 common shares of $1 each and 1.500 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Room 415.1010 St.Catherine Street West.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 5147 l-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec.September 19th, 19Ô9, Vol.91, No.38 3709 (P.G.10788-59) o.R.Products (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en «late du deux juin 1959, constituant en corporation: John Miner, Kazamierez Leopold Lubecki, tous deux de Granby, Russell YY.Price, fils.Russell Price, père, tous deux de Newton.Mass.E.U.A., tous industriels, pour les objets suivants: Fabriquer et en général, faire le commerce d'accessoires d hôpitaux, produits connexes, chaussures de confection spécialisée pour hôpitaux et autres sortes de chaussures et marchandises en cuir, sous le nom de \"G.R.Products (Canada) Ltd.\", avec un capital total de 820,000.divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby.district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le deux juin 1959.1/Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13520-59) Paul & Robert.Limitée Avis est donné qu en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1959, constituant en corporation: Robert Nadeau, marchand.Louis Paradis, avocat, et Julienne Bélanger, secrétaire, célibataire, tous «le Sept-Iles.pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de la toile, «lu coton, «le la laine et autres substances fibreuses, sous le nom de \"Paul & Robert, Limitée\", avec un capital total de 8-10.000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 503.avenue Arnaud.Sept-Iles.district judiciaire de Sagucnay.Daté du bureau «lu Procureur général, le dix-neuf juin 1050.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.FRENETTE.(A.G.10788-59) o.R.Products (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the second day of June, 1959, incorporating: John Miner, Kazamierez Leopold Lûbecki, both of Granby, Russell \\V.Price Jr.and Russell Price Sr., both of Newton, Mass.U.S.A., all industrials, for the following purposes: To manufacture and generally deal in hospital supplies, allied products, specialized footwear for hospital and other types of shoes and leather goods, under the name of \"O.R.Products (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 200 common shares of 8100 each.The hca«l office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of,the Attorney General, this second dav of June.195!).P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.fA.G.13520-59) Paul & Robert.Limiter Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the nineteenth day of June.1959, incorporating: Robert Na-«leau.merchant, Louis Paradis, advocate, and Julienne Bélanger, secretary, spinster, all of Sept-Iles.for the following purposes: To manufacture and carry on a business dealing in linen, cotton, wool ami in other fibrous substances, under the name of \"Paul & Robert, Limitée\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of 8100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 503 Arnaud Avenue, Sept-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13407-59) Peldue Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du «piatre juin 1959, constituant en corporation: Perry Meyer, de Montréal, Hyman Solomon, «le ville Mont-Royal, Louis Feigenbaum, «le St-Laurent, et Philip Meyerovitch, conseil en loi «le ia Reine, «le Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et portefeuille, sous le nom de \"Peldue Investment Corp.\", avec un capital total de 81,000, divisé en 1.000 actions de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le «piatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(A.G.13407-59) Peldue Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing-date the fourth day of June, 1959.incorporating: Perry Meyer, of Montreal, Hyman Solomon, of the town of Mount Royal, Louis Feigenbaum.of St.Laurent, and Philip Meyerovitch, Queen's Counsel, of Montreal, all attorneys, for the following purposes : To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Peldue Investment Corp.\", with a total capital stock of $1,000.divided into 1.000 shares of 81 each.The head office of the company will be at Côte Saint Luc, judicial district of M ont real.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of June.1959.P.FRENETTE, 51471-t) Acting Deputy Attorney General. 3710 UAZKTTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 .septembre 19Ô9.Tome 91.N° 8ft (P.G.13175-50) Pelnar Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1959, constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en Loi, de Ville Mont-Royal, Ernest William Mockridge, gérant, de St-Lambert, Clifford George Meek, de Montréal, et Guy Ambrose Miller, «le St-Rruno, tous deux teneurs de livres, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie «le terrains, immeubles, construction et développement général, en toutes et aucune de ses spécialités, sous le nom de \"Pelnar Construction Inc.'\", avec un capital total «le $40,000, divisé en 800 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune 3,200 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Pro«-ureur général, le douze juin 1059.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.(P.G.14038-59) Pension «lu Nord Limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en «late «lu sept juillet 1959.constituant en corporation: François Francoeur, Raymond Boucher, avocats, et Micheline B.Fréris, secrétaire, tous «le Sept-Iles, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtelier, sous le nom de \"Pension «lu Nord Limitée\", avec un capital divisé en 400 actions sans valeur au pair ou nominale, et 1«- montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est «le $2.000.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay, Daté du bureau «lu Procureur général, le sept juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.(P.G.13462-59) Philippe Gignac Inc.Avis est donné «pi'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu neuf juin 1959.constituant en corporation: Philippe Gignac.entrepreneur briqueteur, William I.Miller, avocat, tous deux «h- Montréal, et Alexander I.Popliger, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs, constructeurs, couvreurs, briqueteurs, importateurs, man hands «-t fabricants «le béton, ciment, asphalte métal en feuilles, préparations pour les toits et autres matériaux utilisés directement ou indirectement par les entrepreneurs, constructeurs ou couvreurs, sous le nom «le \"Philippe Gignac Inc.\", avec un capital total «le $25.000.divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées «le $10 chacune.I/C siège social «le la compagnie sera 5873 rue Chabot, Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.13175-59) Pelnar Construction Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Liiutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June.1959, inicorporating: William Patrick Crcagh.law clerk, of the town of Mount Royal, Ernest William Mockridge.manager, of St.Lambert.Clilfortl George Meek, of Montreal, and Guy Ambrose Miller, of St.Bruno, both bookkeepers, for the following purposes: To carry on the business of a land, real estate, construction and general «levelopmcnt company in any and all its branches, under the name of \"Pelnar Construction Inc.with a total capital stock of $40,000, divided into S00 common shares of a par value «>f 810 each and 3,200 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dat«>d at the office «>f the Attorney General, this twelfth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14038-59) Pension «lu Nord Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of July, 1959.incorporating: Eram.ois Francoeur, Raymond Boucher, advocates, ami Micheline B.Fréris, secretary, all of Sept-Iles, for the following purposes: To operate a business as hotel-keeper, under the name of \"Pension «lu Nord Limitée\", with a capital stock divided into 400 shares without nominal «»r par value, ami the amount with which the company shall start its operations is $2.000.The- head office of the company will be at Sept-Iles, judicial «listrict of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of July, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13462-59) Philippe Gignac Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1959.incorporating: Philippe Gignac, bricklayer contractor.William I.Miller, advocate, both of Montreal, and Alexander I.Popliger.advocate, of Westmount.for the following purposes : To cany on business as contractors, builders, roofers, bricklayers, importers, dealers in ami manufacturers of concrete, cement, asphalt, sheet metal, roof preparations, and other materials used directly or indirectly by contractors, builders or roofers, under the name of \"Philippe Gignac Inc.\", with a total capital stock of $25.000.divided into 500 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 5S73 Chabot Street, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91.No.38 3711 Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.12380-59) Pyromors of Canada Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit juin 1959, constituant en corporation : Fernand Beauregard, procureur, Olga Pope, secrétaire, épouse séparée de biens de Ben Porn-et Micheline Tabacman, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, louer ou autrement acquérir, posséder, administrer, réparer ou contribuer aux réparations d'immeubles de toutes sortes et vendre, hypothéquer ou autrement disposer de ces biens immobiliers, sous le nom de \"Pyromors of Canada Ltd.\".avec un capital total'de 840.000.divisé en 150 actions ordinaires de 8100 chacune et 250 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 900 ouest, rue Jean Talon.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.(P.G.13711-59) Koléon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutcnant-gouvei neur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1959.constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, avocat, d'Outremont.Micheiinc Corbeii, avocate, célibataire, de Montréal, et Léon Giguère.agent d'immeubles, de Pont-Viau, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Roléon Inc.\".avec un capital total de 840.000.divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 274, rue des Écores.Pont-Viau, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.5147l-o P.FRENETTE.(P.G.13129-59) Roll-Y-Rush Home Maintenance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juin 1959, constituant en corporation: Morris Chaikelson, avocat, de Montréal, Morris Shutcr, comptable, de St-Laurent, Gisèle Le-Blanc, secrétaire, épouse séparée de biens de Marcel LeBlanc, de St-Bruno, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entretien domestique, sous le nom de \"Roll-Y-Rush Home Maintenance Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 00 actions privilégiées de 8100 chacune.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of June.1059.P.FRENETTE, 51471-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12380-59) Pyromors of Canada Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of June.1959.incorporating: Fernand Beauregard, attorney.Olga Pope, secretary, wife separate as to property of Ben Pope, and Micheline Tabacman, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To buy, rent or otherwise acquire, own.administrate, repair or contribute to the repairs of immoveables of all kinds, and sell, mortgage or otherwise dispose of these immoveables, under the name of \"Pyromors of Canada Ltd.\", with a total capital 'stock of 840.000, divided into 150 common shares of 8100 each and 250 preferred shaies of 8100 each.The head office of the company will be at 900 Jean Talon Street West.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of June.1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13711-59) Roléon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June, 1959.incorporating: Henri-Paul Lemay, advocate, of Outremont.Micheline Corbeil, advocate, spinster, of Montreal, and Léon Giguère, real estate agent, of Pont-Viau, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Roléon Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a par value of 81 each and 390 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 274 des Écores Street.Pont-Viau, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of June.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13129-59) Roll-Y-Rush Home Maintenance Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1959, incorporating: Morris Chaikelson.advocate, of Montreal, Morris Shuter.accountant, of St.Laurent, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate as to property of Marcel LeBlanc.of St.Bruno, for the following purposes: To carry on generally the business of domestic maintenance, under the name of \"Roll-Y-Rush Home Maintenance Inc.\".with a total capital stock of 810,000, divided into 4.000 common shares of $1 each and 60 preferred shares of $100 each. 3712 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° 38 -1- Le siège social de la compagnie sera à Al ont n'ai, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51171 P.FRENETTE.(P.G.13013-59) Ste-Geneviève Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juillet 1959, constituant en corporation: Armand Poupart fils, avocat.Mlles Jacqueline Matce et Monique Duquette, sténographes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Ste-Geneviève Construction Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 30SS.montée St-Jean, municipalité de Dullard des Ormeaux, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51171-o P.FRENETTE.The head office of the company will be ;it Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13013-59) Stc-Genevicve Construction Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin Province of Quebec, bearing date the sixth day ol July, 1959, incorporating: Armand Poupart.junior, advocate.Misses Jacqueline Matte and Monique Duquette, stenographers, all of Mont real, for the following purposes: To carry on the business of a construction coin pany, under the name of \"Ste-Geneviève Coin truction Inc.' , with a total capital stock of 850,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at 39SS Montée St.Jean, municipality of Dollard des Ormeaux, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of July,*1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13844-59) St.George Motor Hotel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf juin 1959,constituant en corporation: Guillaume-Guy Dancau, entrepreneur.Adrien Cinq-Mars, comptable agréé, tous deux de Montr al, et Jean-Paul Gagné, avocat et conseil en toi de la Reine, de Vide Mont-Royal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et de construction et faire affaires comme hôteliers, sous le nom de \"St.George Motor Hotel Inc.\", avec un capital total de 840,000.divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pointeaux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471-0 P.ERENETTE.(P.G.12707-59) St.Jérôme County Realty (Que.) Inc.Avis est donné «pi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a «'té aceortlé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier juin 1959.constituant en coiporation: Daniel Kingstone, Samuel Godinsky, avocats, Claire Lubin, et Katherine Ingledew,sténographe, célibataires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Agir et exercer le commerce comme une compagnie d'habitations à dividende limité, tel que défini par la Ix>i «le l'Habitation nationele 1954, et amendements (2-3) Elizabeth II, chapitre 23, sous le nom de \"St.Jérénne County Realty (Que.) Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.(A.G.I3S44-59) St.George Motor Hotel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Qiielwc Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1959, incorporating: Guillaume-Guy Daneau, contractor, Adrien CimpMars, chartered accountant, both of Montreal, and Jean-Paul Gagné, advocate and Queen's Counsel, of the town of Mount-Royal, for the following purposes: To carry on a real estate and construction business and to operate as hotel-keei>ers.under the name of \"St.George Motor Hotel Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Pointe-aux-Trembles, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June.1959.P.FRENETTE.51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12707-59) St.Jérôme County Realty (Que.) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of June, 1959.incorporating: Daniel Kingstone, Samuel Godinsky, advocates, Claire Lubin and Katherine Ingledew, Stenographers, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To act and carry on business as a limited dividend housing company as defined by the National Housing Act 1954, and amendments (2-3) Elizabeth II, Ch.23, under the name of \"St.Jérôme County Realty (Que.) Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 40.000 shares of a par value of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Sevtember 19th, 7.959.Yol.'U.A'o.38 3713 Ix> siège social do la compagnie sera à Montreal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13411-59) St.Philippe Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dos compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piatre juin 1959.constituant en corporation: Perry Meyer, Philip Meyerovitch, conseil en loi de la Reine, tous deux de Montréal, Hyman Solomon, de Ville Mont-Royal, et Louis Feigen-li.ium, de St-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de pla-ci monts et de portefeuille, sous le nom de \"St.Philippe Realty Corp.\".avec un capital total de SI.000, divisé en 1.000 actions de SI chacune.Ix- siège social de la compagnie sera à Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13411-59) St.Philippe Realty Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of Juno, 1959, incorporating: Perry Meyer.Philip Meyerovitch, Queen's ( Counsel, both of Montreal.Hyman Solomon, of the Town of Mount Royal, and Louis Feigenbaum, of St.Laurent, all attorneys, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"St.Philippe Realty Corp.\".with a total capital stock of 81.000.divided into 1.000 shares of SI each.The head office of the company will be at Côte Saint Luc.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of Juno.1959.P.FRENETTE.5l471-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.13412-59) St.Raphael Enterprises Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piatre juin 1959, constituant en corporation: Perry Meyer, Philip Meyerovitch, conseil on loi de la Reine, tous deux de Montréal, Hyman Solomon, de Ville Mont-Royal, et Louis Feigenbaum, de St-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et portefeuille, sous le nom do \"St.Raphaël Enterprises Corp.\", avec un capital total de 81.000.divisé en 1.000 actions do SI chacune.Ix' siège social de la compagnie sera à Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le \u2022piatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.\u2022M471 P.FRENETTE.(A.G.13412-59) St.Raphaël Enterprises Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1959.incorporating: Perry Meyer, Philip Meyerovitch.Queen's Counsel, both of Montreal.Hyman Solomon, of the Town of Mount Royal, and Louis Feigenbaum, of St.Laurent, all attorneys, for the following purposes : To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"St.Raphaël Enterprises Corp.\".with a total capital stock of 81.000.divided into 1.000 shares of SI each.The head office of the company will be at Côte Saint Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June.1959.P.FRENETTE.5l471-o Acting Deputy Attorney (Jouerai.(A.G.13410-59) St.Raphael Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Qu'bec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 1959.constituant en corporation: Perry Meyer, Philip Meyerovitch, conseil en loi de la Reine, tous deux de Montréal.Hyman Solomon, de Ville Mont-Royal, et Louis Feigenbaum, de St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et portefeuille, sous le nom de \"St.Raphaël Investment.Corp.\", avec un capital total de 81.000, divisé en 1,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Côte Saint Luc.(listrict judiciaire de Montréal.(A.G.13410-59) St.Raphaël Invest nient Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1959, incorporating: Perry Meyer.Philip Meyerovitch.Queen's Counsel, both of Montreal, Hyman Solomon, ol the town of Mount Royal, and Louis Feigenbaum.of St.Laurent, all attorneys, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"St.Raphaël Investment Corp.\".with a total capital stock of 81.000.divided into 1.000 shares of 81 each.The head office of the company will be at Côte Saint Luc.judicial district of Montreal. .{714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° 88 Daté «lu bureau du Procureur général, le quatre juin 1959.1/ Yssislant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13406-59) St.Raphaël Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 1959, constituant en corporation: Perry Meyer.Philip Meyerovitch, conseil en loi de la Reine, tous deux de .Montréal, Hyman Solomon, de Ville Mont-Royal, et Louis Feigenbaum.de St-Laurent.tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"St.Raphaël Realty Corp.\", avec un capital total de 81,000.divisé en 1,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à (Y)te Saint-Luc.district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of .lune.1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13400-59) St.Raphael Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor ol the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1959.incorporating: Perry Meyer, Philip Meyerovitch.Queen's Counsel, both of Montreal, Hyman Solomon, of the town of Mount Royal, and Louis Feigenbaum, of St.Laurent, all attorneys, for the following purposes: To carry on business as an investment ami holding company, under the name of \"St.Raphael Realty Corp.\".with a total capital stock of SI,000, divided into 1.000 shares of SI each.The head office of the company will be at Côte Saint Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of June 1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14036-59) Scpt-Ilcs Masonry Ltd.Maçonnerie Sept-Iles Liée Avis est donn'\"' qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagmes de Québec, il a ét'* accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juillet 1959, constituant en corporation: Joseph Vézina, gérant, Charles-A.Rigonnesse, comptable, et François Francoeur, avocat, tous de Sept-Iles, pour les objets suivants: Industrie et commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Sept-Iles Masonry Ltd.\u2014 Maçonnerie Sept-Iles Ltée\", avec un capital total de S20.000, divisé en 100 actions communes de 8100 chacune et en 100 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le sept juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-o P.FRENETTE.(P.G.13697-59) Sholcui Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit juin 1959, constituant en corporation: Albert Marcus.Abraham Feiner et Isidore Reuben Prazoff, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et améliorations, sous le nom de \"Sbolem Corporation\", avec un capital total de 85,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, dsitrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit juin 1959.L'Assistant-procureur général suppliant.51471 P.FRENETTE.(A.G.14036-59) Sept-Iles Masonry Ltd.Maçonnerie Sept-Iles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tlu-Province of Quebec, bearing date the seventh day of July 1959, incorporating: Joseph Vézina, manager, -Charles-A.Rigonnesse.accountant, and François Francoeur, advocate, all of Sept-Iles, for the following purposes: To carry on the business of and deal in building materials, under the name of \"Sept-Iles Masonry Ltd.\u2014 Maçonnerie Sept-Iles Ltée\", with a total capital stock of 820,000, divided into 100 common shares of 8100 each and 100 preferred shares of $100 each.The bead office of the company will be at Sept-Iles, judicial «listrict of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this seventh dav of July.1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13097-59) Sholeni Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the eighteenth day of June, 1959, incorporating: Albert Marcus, Abraham Feiner and Isidore Reuben Prazoff, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a real estate and improvement company, under the name of \"Sliolem Corporation\", with a total capital stock of 85,000, divided into 5,000 common shares of SI each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, 1969, Vol.01, No.88 3715 (P.G.13536-59) Sidepal Corp.Avis est donné qu'en vertu de hi première partie «le la I/oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1959.constituant en corporation: Benjamin Robinson, Joseph Shapiro, tous deux avocats, et conseils en loi de la Reine, do Westmount.et Ethel Yussem, secrétaire, fille majeure, de Montrerai, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agents d'immeubles dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Sidepal Corp.\".avec un capital-actions divisé tu 100 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de S500.Ix' siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13595-59) Tareen Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I.x>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date ¦ lu quinze juin 1959.constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en loi de Ville Mont-Royal, Ernest William Mockridge, gérant, \u2022 le St-Lambert, ClilFord George Meek, de Montréal, et Guy Ambrose Miller, de St-Rruno, tous deux teneurs de livres, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, immeubles, construction et développement en général, sous le nom de \"Tareen Development Inc.\", avec un capital total de S10.000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de 810 chacune.Ix> siège social de la compagnie sera à Montréal, \u2022 listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.(P.G.13403-59) The Killarney Club of Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date \u2022 lu (piatre juin 1959, constituant en corporation sans capital-actions: James Halpin, pharmacien.Majella Haberlin, administratrice.Edward F.Walsh.C.Stuarl Mackay, ingénieurs, Thomas W.Brown, avocat.J.Larkin Keiwin.professeur, tous les six «le Sillery, Maurice Edwards, Austin Kdwards, tous deux photographes, de Ste-Foy, et William Delanoy.médecin, de Québec, poulies objets suivants: Organiser, construire et gérer un camp d'été pour les garçons catholiques, de langue anglaise de la cité de Québec et de la région, sous le nom de \"The Killarney Club of Quebec Inc.\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est S 150.000.Le siège social de la corporation sera à Saintc-Foy, district judiciaire de Québec.(A.G.13536-59) Sidepul Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec-, bearing date the ninth day of June, 1959.incorporating: Benjamin Robinson.Joseph Shapiro, both advocates and Queen's Counsels, of Westmount.and Ethel Vussem, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate agents in all its branches, under the name of \"Sidepal Corp.\", with a capital stock divided into 100 common shares without nominal or par value, and the amount with which the company will commence its operations will be 8500.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of June.1959.P.FRENETTE, 5147l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13595-59) Tareen Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June.1959.incorporating: William Patrick Creagh.law clerk, of the Town of Mount Royal.Ernest William Mockridge.manager, of St.Lambert, Clifford Geoige Meek, of Montreal, and Guy Ambrose Miller, of St.Bruno, both bookkeepers, for the following purposes: To carry on the business of a land, real estate, construction and general development company, under the name of \"Tareen Development Inc.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 1.000 shares of a par value of 810 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13403-59) The Killarney Club of Quebec Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1959.to incorporate as a corporation without share capital: James Halpin, pharmacist, Majella Haberlin, executive, Edward P.Walsh, C.Stuart MacKay.engineers.Thomas W.Brown, advocate.J.Larkin Kerwin.professor, all six of Sillery, Maurice Edwards.Austin Edwards, both photographers, of Ste.Foy, and William Delaney, medical doctor, of Quebec, for the following purposes : To organize, construct and operate a summer camp for English speaking Catholic boys of Quebec City and region, under the name of \"The Killarney Club of Quebec Inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited, is 8150.000.The head office of the corporation will be at Sainte Foy.judicial district of Quebec. 3716 GAZETTE OFFH1ELLE DE QUÉBEC, Québec 19 septembre 19Ô9, Tomt 91, Nc 88 Daté du bureau «lu Procureur général, le quatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 5Ï471 P.FRENETTE.(P.G.13320-59) The Naftali Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant -gouverneur de la province de- Québec des lettres patentes, en date du premier juin 1959.constituant en corporation; Gregory Charlap.Max Slapack et Arthur Shul-man, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général île courtiers en immeubles et agents à commission, sous le nom de \"The Naftali Corporation\", avec- un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 1 .(100 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de SI chacune et 3S0 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5757 avenue Décolles, chambre 415, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51471-0 Ac-ting Deputy Attorney General (A.G.13320-59) The Naftali Corporation Notice is hereby given that, under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of June, 1959.incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack and Arthur Shulman.all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business generally as real estate brokers and commission agents, under the- name of \"The Naftali Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each, 1.999 Class \"A\" preferred shares of a par value of SI each and 380 Class \"B\" preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 5757 Décolles Avenue, Room 415.Montre,I judicial district of Montreal.Dated at the office- of the Attorney General, this first dav of June, 1959.P.FRENETTE.51471-0 Acting Deputy Attorney (Jouerai.(P.G.13553-59) Turin Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1959, constituant en corporation: Harry L.Aronovitch, avocat, de Côte St-Luc, Samuel ('hait, Maxwell ShenKer, tous deux avocats, et John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Turin Development Corporation\", avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une aleur au pair de Si chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera 1255 rue University, suite 1012, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.(P.G.13405-59) Valduc Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec clos lettres patentes, en date du quatre juin 1959, constituant on corporation: Perry Meyer, Philip Meyerovitch, conseil en loi de la Reine, tous deux de Montréal, Hyman Solomon, de ville Mont-Royal, et Louis Feigenbaum, de St-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et portefeuille, sous le nom de \"Val-duc- Development Corp.'', avec un capital total (A.G.13553-59) Turin Development Corporation Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act.letters patent have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth clay of June, 1959, incorporating: Harry L.Aronovitch, advocate, of Côte St.Luc.Samuel Chait, Maxwell Shenker, both advocates, and John Hamilton, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Turin Development Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $1 each and 36.000 preferred shares of a par value of SI each.The bead office of the company will be at 1255 University Street, suite 1612.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Gênerai, this tenth dav of June.1959.P.FRENETTE.51471-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13405-59) Valdue Development Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin Province of Quebec, bearing date the fourth clay of Juno, 1959, incorporating: Perry Meyer, Philip Meyerovitch, Queen's Counsel, both of Montreal.Hyman Solomon, of the town of Mount Royal, and Louis Feigenbaum, of St.Laurent, all attorneys, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Valduc Development Corp.\".with a total capital stock QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.38 3717 de SI.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $] chacune.Le siège social de la compagnie sera à Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 'liiatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.FRENETTE.(P.G.12487-59) Verdun Business College Inc.Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit juin 1959, constituant en corporation: Kenneth Wright Williamson, professeur, de Ville Brassard, Gordon Farl Buchner, professeur et Marie-Yvonne Williamson Buchner, professeur épouse séparée de biens dudit Gordon Earl Buchner, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de Ville LaSalle, pour les objets suivants: Acheter, posséder, conduire et exploiter une ¦'\u2022cole ou des écoles à des fins d instruction se rapportant aux affaires, sténographie, travail de secrétaire, tenue de livres, comptabilit'\" et en général, procédures commerciales et administration, sujets techniques et autres sujets connexes et objets relatifs aux affaires, sous le nom de \"Verdun Business College Inc.\", avec un capital total de 840.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Verdun, ¦ listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le iniit juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, \".1471 P.FRENETTE.P.G.13420-59) West more Realty Corp.Avis est donn» qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piatre juin 1959.constituant en corporation: iVJoe Ackinan, de L'Àbord-à-Plouffe, Irwin Gli-serman, de la ville Côte St-Luc, et Sidney Cutler, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Westmorc Realty Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de 810 chacune et 500 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à .Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le «piatre juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471 P.ERENETTE.(P.G.13704-59) Wilfrid Chapdelainc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin 1959.constituant en corporation: Lucien Roux, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount, -J.-Clovis Dagenais, avo- of $1,000, divided into 1,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Côte Saint-Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1959.P.FRENETTE, 51471 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12487-59) Verdun Business College Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of June, 1959.incorporating: Kenneth Wright Williamson, teacher, of Ville de Brossard, Gordon Farl Buchner, teacher, and Marie-Yvonne Williamson Buchner, teacher, wife separate as to property of the said Gordon Earl Buchner, and duly authorized by him for these presents, both of Ville LaSalle, for the following purposes: To purchase, own, conduct and operate a school or schools for instructional purposes in connection with business, stenography, secretarial work, bookkeeping, accounting and general business procedure and administration, technical subjects, and other ancillary subjects and objects in relation to business, under the name of \"Verdun Business College Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of June, 1959.P.FRENETTE.51471 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13426-59) Westmorc Really Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant'Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June.1959.incorporating: Moc Ackman, of L'Abord-à-Plouffe, Irwin Gliserman, of the town of Côte St.Luc.and Sidney Cutler, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Westmorc Realty Corp.\", with a total Capital stock of 810.000.divided into 500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of June.1959.P.FRENETTE, 51471-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13704-59) Wilfrid Chapdelainc Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of June.1959, incorporating: Lucien Roux, advocate and Queen's Counsel, of West-mount, J.-Clovis Dagenais.advocate and Queen's 3718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 19,59, Tome 91, N° 88 cat et conseil en loi de lu Reine, Jules Couture, courtier.Lorraine Côté et Claire Couture, secrétaires, filles majeures, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie de manufacturiers et raffi-neurs d'huile, graisse, pétrole et leurs sous-produits, et en faire le commerce, sous le nom de \"Wilfrid Chapdelaine Inc.\", avec un capital total de $20.000, divisé en 1.000 actions d'une valeur au pair de $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sorcl.i du régime des eaux courantes.Statuts refondus, 1941, chapitre 98.Formule l 1\u2014 (ArticIeS) Avis de dépôt des plans et devis.Avis est donné au public, conformément à l'article 8 de la Ix>i du régime des eaux courantes, Îue \"1.41 Sarre Power Company Limited\" de ai Sarre dans le comté d'Abitibi-Ouest se propose de demander l'autorisation de remplacer un barrage en bois existant par un barrage de béton sur la rivière La Sarre au lot N° 22, du .rang IX du canton I.#a Sarre, comté d'Abitibi-Ouest.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant l'emplacement choisi pour la construction de ces ouvrages a été transmise au ministre des ressources hydrauliques et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau «le la division d'enregistrement du comté d'Abitibi-Ouest à Amos.La demande contenue dans la requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Le Requérant, PIERRE LANGEAIS, Ing.P., 51455-37-4-0 La Sabre Power Co.Ltd.(P.G.9043-50) NOE ROURASSA, LIMITÉE Règlement N° s li Augmentant le nombre des directeurs de cinq à huit.\"A l'avenir, les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction composé de huit directeurs qui seront 'Mus pour une année et qui seront toujours ré-éligibles\".Daté à Ville Mont-Royal, ce 10 juillet 1959.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 51473-0 L.TESSIER.(P.G.10372-57) DAVID & FRÈRE, LIMITÉE Extrait des minutes d une assemblée générale spéciale des actionnaires, catégorie \"R\" de \"David & Frère.Limitée\" tenue le 3 juillet 1959.Règlement N° 1IJ, \"Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de sept à huit: et que le règlement N° 111 soit abrogé.Vraie copie certifiée.(Signé) lAi Secrétaire.51474 RODIER MERRILL.(P.G.13700-57) CENTRAL TRUCK LINES LTD.Règlement N° (i Que le nombre des directeurs soit diminué de six à trois directeurs, de sorte (pie le bureau de direction sera composé à l'avenir de trois directeurs.Miscellaneous notices LA SARRE POWER COMPANY LIMITED Water-Course Act, Revised Statutes, 1941, chapter 98.Form t 1.\u2014 (Section 8) Notice of deposit of plans and specifications.Public notice is hereby given, in accordance with section 8 of the Water-Course Act, that \"La Sarre Power Company Limited\", of Li Sarre in the county of Abitibi-West, intends to apply for authorization to replace an existing wooden dam by a concrete dam on the river La Sarre bordering lot No.22, range IX of the township of La Sarre, county of Abitibi-West.Notice is also given that a petition to thai effect, accompanied by plans and specifications showing the site chosen for the construction thereof, has been forwarded to the Minister of hydraulic resources and that a duplicata of said plans and specifications has been deposited at the registry office of the county of Abitibi-West, at Amos.The application contained in the petition shall be taken into consideration on or after the day following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.PIERRE LANGEAIS, P.Eng., Petitioner, 51455-37-4 La Sarre Power Co.Lti>.(A.G.9043-50) NOÉ ROURASSA, LIMITÉE By-Law No.S li Increasing the number of directors from five I\" eight.Hereafter, the affairs of the company shall be managed by a Hoard of Directors composed of eight directors, elected for one year, and they shall always be re-eligible\".Dated at the town of Mount Royal, this July 10.1959.Certified true copy.L.TESSIER, 51473 Secretary.(A.G.10372-57) DAVID & FRÈRE, LIMITÉE Extract of the minutes of a special general meeting of shareholders class \"R\" of \"David & Frère.Limitée\" held on July 3rd, 1959.By-law No.11.', \"That the number of the company's directors be hereby increased from seven to eight; and that by-law No.Ill be rescinded.Certified true copy.(Signed) RODIER MERRILL.51474-o Secretary.(A.G.13700-57) CENTRAL TRUCK LINES LTD.By-law No.6 That the number of the directors be decreased from six to three directors in order that the board of directors be composed, in future, of three directors. QUEBEC OFFICIA I.GAZETTE, Quebec, September 10th, 1059, Vol.01, No.88 3721 Que le règlement \\° 3 de notre compagnie en date du 4 juin 1952, lequel avait changé le nomine de directeurs de trois à six, soit résilié.Que l'article 9 du règlement N° 1, soit en conséquence remis en force tel qu'il existait à I origine.Vraie copie certifiée du règlement N° 0 de \u2022«'entrai Truck Lines Ltd.f, adopté à une assemblée des directeurs de ladite compagnie, tenue le 12 février 19.59, à 10.00 a.m.ratifié, i nfirmé et sanctionna lors d une assemblée des actionnaires de la même compagnie tenue le même jour et auxquelles assemblées tous les directeurs et actionnaires de la compagnie ont accepté.Donné à Val d'Or, ce 12 février 1959.Le Secrétaire, 75-o FERNAND LAROCQUE.P.G.10829-55) « OXSOIIDATED HALLIWELL LIMITED (No Personal Liability) Règlement N° M jour augmenter le nombre des directeurs et fixer le quorum.Qu'il soit et il est.par les présentes, décrété comme le règlement N° 10 de \"Consolidated llalliwell Limited' (No Personal Liability), que: 1° Le nombre, des directeurs de la compagnie soil augmenté de cinq à neuf; 2° Quatre (4) directeurs formeront quorum; et 3° Les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés en conséquence.Pass\" et décrété par le bureau de direction, ce 10e jour d avril 1959.Témoin: Le sceau corporatif.Vraie copie certifiée.(S.C.) Le Président.W.P LEX.M AN.Le Secrétaire, IS5 G.D.PATTISON.That by-law No.3 of our company dated dune 4, 1952, by which the number of directors was changed from three to six, be cancelled.That article 9 of by-law No.1, therefore be restored and put into force as it was originally.True certified copy of by-law No.0 of \"Central Truck Lines Ltd.\", adopted at a meeting of the directors of the said company, held on February 12, 1959 at 10.00 a.m., ratified, confirmed and sanctioned at a meeting of the shareholders of the same company held on the same day and at.which meetings, all the directors and shareholders of the company, duly accepted.Given at Val d'Or, this 12th dav of February, 1959.FERNAND LAROCQUE, 51475 Secretary.(A.G.10829-55) CONSOLIDATED IIALLIWELL LIMITED (No Personal Liability) By-law No.1G to increase the number of directors and fix the quorum.Re it and it is hereby enacted as by-law No.10 of \"Consolidated llalliwell Limited\" (No Personal Liability), that: 1.'The number of directors of the company be increased from five to nine; 2.Four (4) directors shall constitute a quorum ; and 3.The by-laws of the company be and they arc hereby amended accordingly.Passed and enacted by the board of directors this 10th day of April, 1959.As withncss: The corporate seal.Certified a true copy.(C.S.) W.PLEXMAN, President.G.D.PATTISON, 51485-o Secretary.(P.G.10047-59) FOUNDATION STEEL SPECIALTIES INC.Règlement N° XIV Que le nombre des directeurs de la compagnie \u2022-oit augmenté de trois (3) à (piatre (4) directeurs.Montréal, le 22 juillet 1959.(Sceau) Le Secrétaire.51486-0 (S) GUY R.SAUCIER.1 P.G.11017-58) MARCHÉ UNION INC.Eu-trait du règlement N° 24 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Marché Union Inc.\", ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de < piatre à Cinq, de manière (pie le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de cinq directeurs.le, le soussigné, Hyman Wienstcin, Président de \"Marché Union Inc.\", certifie, par les présentes, que le précédent est une copie véritable et eonforme du règlement N° 24 décrété à une assemblée du bureau de direction de cette compagnie tenue à Montréal, le 20c jour de juin 19,59 et sanctionné et approuvé par les actionnaires à leur assemblée générale, spéciale tenue (A.G.10047-59) FOUNDATION STEEL SPECIALTIES INC.By-Law No.XIV That the number of the directors of the company be increased from three (3) to four (4) directors.Montreal, July 22, 1959.(Seal) (S) GUY R.SAUCIER, 51480 Secretary.(A.G.11017-58) MARCHÉ UNION INC.Extract from by-law No.24 Re it enacted and it is hereby enacted as a bylaw of \"Marché Union Inc.\", as follows: 1.That the number of directors of the company be and the same are hereby increased from four to five, so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of five directors.I, the undersigned, Hyman Wienstein, President of \"Marché Union Inc.\", do hereby certify that the foregoing is a true and correct extract of by-law No.24 enacted at a meeting of the board of directors of this company held at Montreal on the 20th day of June 1959 and sanctioned and approved by the shareholders at their special general meeting held on the 20th day of 3722 GAZETTE OFFICIEL LE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 19Ô9, Tome 91, .V° 8S le 26e jour de juin 1959, dûment convoquée aux fins do considérer ledit règlement, et à laquelle, il y eût vote en faveur dudit règlement par les actionnaires représentant toutes les actions émises et en cours du capital-actions de la compagnie.(Sceau) Le Président, 51500 IL WIENSTEIN.lune 1050.duly called for considering the said by-law, at which meeting there voted in favour of the said by-law shareholders representing all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the company.(Seal) II.WIENSTEIN, 51500-o President.(P.G.3073-51) ED.ARCHAMBAULT, INCORPORÉE Règlement spécial \"A\" Qu'il soit décrété et il est par les présentes décrété et adopté connue règlement spécial \"A\" de la compagnie: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est par les présentes réduit de cinq (5) à (piatre (4), de façon à ce (pie le Bureau de direction soit, à compter de l'approbation du présent règlement par les actionnaires de la Compagnie, et de sa publication dans la Gazette Officielle de Québec, formé de (piatre (I) directeurs: 2° Que le quorum aux assemblées des directeurs de la compagnie soit fixé à trois (3) directeurs; 3° Que tous les règlements, résolutions et procédures de la compagnie, incompatibles avec le présent règlement et plus particulièrement l'article S des règlements généraux de la compagnie, soient et ils sont par les présentes amendés, modifiés et abrogés on autant qu'il est nécessaire pour donner plein effet au présent règlement.Certifié vraie copie du règlement spécial \"A\", décrété par les directeurs de \"Ed.Archambault, Incorporée\", à une assemblée dûment tenue à Montréal, le 20 mars 1050, et subséqutmment approuvé et ratifié à l'unanimité par tous les actionnaires présents et formant, quorum à une assemblée générale spéciale de ceux-ci Jument convoquée et tenue à Montréal, le 15 mai 1959.Le Secrétaire, 51501-o ROSAIRE ARCHAMBAULT.(P.G.8479-41) LA LAITERIE PAR EON DE VAL.LIMITEE Règlement A'° h (Concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à (piatre) Qu'il soit et il est par les présentes adopté comme règlement N° 4 de \"La Laiterie Parfon-deval, Limitée\": Que le bureau de direction sera composé de (piatre actionnaires à compter de la date de la publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec.Vraie copie certifiée du règlement N° 4 de \"La Laiterie Parfondoval Ltée\", adopté à l'unanimité lors d'une assemblée des actionnaires de ladite compagnie le 24 décembre 1058 et à laquelle tous les actionnaires étaient présents.Ix> Secrétaire, 51504-o ARMANI) GILBERT.(P.G.47083-53) QUICK FLAME GAS LTD.Règlement spécial \"A\" (1959) 1° Le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de trois (3) à sept (7).2° Lorsque le présent règlement sera devenu valide, les directeurs en fonctions à cette époque (A.G.3073-51) ED.ARCHAMBAULT, INCORPORÉ!-: Special by-law \"A\" Be it enacted and it is hereby enacted and adopted as Company's Special By-law \"A\": 1.That the number of directors of the coin, pany be decreased and the same is hei bv decreased from five (5) to four (4), in order lli.it the board of directors be, from and after confirmation of this by-law by the shareholders of I he company, and the publication thereof in the Quebec Official Gazette, formed of four (4) i tors: 2.That quorum at meetings of directors of the company be fixed at three (3) directors; 3.That all the by-laws, resolutions and proceedings of the compdny inconsistent therewith and more particularly article S of the company's general by-laws, be and they are hereby amended, modified, repealed insofar a- it is necessary to give full effect to this by-law.Certified true copy of special by-law \"A\", enacted by the directors of \"Ed.Archambault.Incorporée\", at a meeting duly held at Montreal, March 20, 1050, and subsequently unanimously approved and confirmed by the shareholders present and forming quorum at a special general meeting of the latter duly called and held al Montreal.May 15, 1050.ROSAIRE ARCHAMBAULT, 51501 Secretary.(A.G.8470-41) LA LAITERIE PARFONDEVAL, LIMITEE By-law No./ (Concerning an increase in the number of directors from three to four) Be it enacted and the same is hereby enacted as by-law No.I of \"La Laiterie Parfondcv d.Limitée\": That the board of directors shall be composed of four shareholders as from the date of the publication of this by-law in the Quebec Official ( 'azette.Certified true copy of by-law No.I of Laiterie Parfondeval Ltée\", unanimously adopted at a meeting of shareholders of said company December 24, 1958 and at which all the shareholders were present.ARMANI) GILBERT, 51504 Secretary.(A.G.47683-53) QUICK FLAME GAS LTD.Special By-law \".I\" (1959) 1.The number of the directors of the com pany is increased from three (3) to seven (7).2.When this by-law shall have become valid the directors then in office may appoint from QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, September 19th.1959, Vol.91, No.38 3723 pourront nommer parmi les actionnaires qualifiés (piatre autres directeurs pour demeurer en fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs.Vraie copie du règlement spécial \"A\" (1950) ci-dessus, adopté par les directeurs à une assemblée tenue le 3 septembre 1959, et approuvé unanimement par les actionnaires à une assemblée générale spéciale tenue à cette fin le I septembre 1959.Montréal, le I septembre 1959.(Signé) Le Secrétaire.51505-o RAYMOND MARTIN.(P.G.15131-59) CHARLES E.FROSST & CO.Règlement spécial \"11\" Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété ce (pli suit: 1° Le nombre des directeurs de la compagnie est.par les présentes, augmenté de sept à huit.2° Les directeurs peuvent en aucun temps antérieur à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie nommer d'entre les actionnaires qualifiés (le la compagnie, un où des directeurs additionnels, jusqu'à ce qu'il y ait élection, en surplus aux directeurs alors en fonction, un nombre suffisant pour compléter entièrement le bureau de huit directeurs.- Montréal.P.Q.Il septembre 1959.( fortifié vraie copie.(Sceau) Le Président.JOHN B.FROSST.Le Secrétaire, 51515 CHARLES E.FROSST.amongst the duly qualified shareholders four other directors to hold office until the next annual general meeting or the clec^bn of their successors.True copy of the above special by-law \"A\" (1959) enacted by the directors at a meeting held on September 3.1959 and approved by the unanimous vote of the shareholders at a special gen ral meeting held on September 4, 1959.Montreal.September-lib.1959.(Signed) RAYMOND MARTIN, 51505-o Secretary.(A.G.15131-5!)) CHARLES E.FROSST & CO.Special by-law \"II\" Be and it is hereby enacted as follows: 1.The number of directors of the company is hereby increased from seven to eight.2.The direct ors may at any time prior to the next annual meeting of the shareholders of the company elect from amongst the qualified shareholders of the company an additional director or directors until there shall have been elected, in addition to the directors then in office, a sufficient number to complete the full board of eight directors.Montreal.P.Q., September 11, 1959.( citified true copy.(Seal) JOHN B.FROSST, President.CHARLES E.FROSST, 51515-( ) Secretary.(P.G.13858-59) CLINIQUE MÉTROPOLITAINE INC.METROPOLITAN (LINK' INC.Règlement \"//\" 1° Ia?nombre des directeurs de \"Clinique Métropolitaine Inc.\".est augmenté de quatorze (14) à seize (10) directeurs; 2° Il y aura quorum à une assemblée des directeurs lorsqu'il y aura neuf (9) directeurs réunis; 3° Les règlements généraux de la compagnie sont modifiés en conséquence.I-o Secrétaire, 51522-0 JACQUES SIM A RI).(P.G.12188-54) LA CORPORATION DES ADMINISTRATEURS PROFESSIONNELS THE CORPORATION OF PROFESSIONAL ADMINISTRATORS Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procurcur général, l'honorable Secrétaire de la province a.le neuf septembre 1959, approuvé les modifications apportées aux articles 15, 10, 17, 18, 19, 20, 23et 24 du règlement général N° 1, et les règlements Nos 2 et 3 de \"La Corporation des Administrateurs Professionnels-The Corporation of Professional Administrators\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Un des compagnies de Québc Sous-secrétaire de la province, 51634-0 RAYMOND DOUVILLE.(P.G.12420-59) GAGNON FRÈRES \"EXÉCUTIF\" LTÉE Règlement N° 8 Il est résolu à 1 unanimité d'adopter le règlement N° 3 à l'effet d'augmenter le nombre des directeurs de trois à (piatre.Vraie copie d'un règlement adopté par les directeurs de \"Gagnon Frères \"Exécutif\" Ltée\", le 30 juin 1959 et ratifié par tous les actionnaires à une assemblée générale spéciale tenue le même jour.Le Secrétaire, 51535-o L.G.GAGNON.(P.G.11870-59) SHORÈCREST DEVELOPMENT INC.Règlement N° 25 (cpii augmente le nombre des directeurs de trois à cinq) \"Les directeurs de la compagnie seront au nombre de cinq.Sur proposition dûment présentée et secondée et adoptée à l'unanimité, il a été résolu que les officiers de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, autorisés et dirigés à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de donner un effet légal au règlement N° 25.\" Vraie copie certifiée du règlement N° 25 tel qu'adopté par les directeurs et approuvé par les actionnaires, le 10 août 1959.Le Secrétaire, 5153(i FRED KOTEX.SYNDICAT IMMOBILIER DE MARIA Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third Copy of the original of the déclarât ion of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Immobilier de Maria\", under date of September 1st.1959, whereof the head office is \u201e| Maria, county of Bonavcnturc, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fourteenth dav of September 1959.RAYMOND DOUVTLLE, 51534 Assistant Secretary of the Province (A.G.12420-59) GAGNON FRÈRES \"EXÉCUTIF\" LTÉ I By-law No.8 It is unanimously resolved to adopt by I No.3 for the purpose of increasing the number i directors from three to.four.True copy of a by-law adopted by the direct\"' of \"Gagnon Frères \"Exécutif\" Ltée\".lune 30 1959 and confirmed by all the shareholders at a special general meeting held the same day.L.G.GAGNON, 51535 Secretary.(A.G.11876-59) SHORECREST DEVELOPMENT INC.By-law No.25 (increasing the number of directors from three to five) \"The directors of the company shall bo five in number.Upon motion duly made and seconded and unanimously adopted, it was resolved that tin officers of the company be and hereby arc -authorized and instructed to take all necessary steps to give legal effect to by-law No.25.\" Certified true copy of by-law No.25, as adopt ed by the directors and approved by the shareholders on August.10th, 1959.FRED KOTEX, 51536-0 Secretary.(P.G.12284-50) LEMOYNE OIL CO.LTD.LA CIE D'HUILE LEMOYNE LTÉE Règlement A Un règlement qui augmente le nombre des directeurs.Le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de trois à cinq et les règlements de la compagnie sont amendés en conséquence.Vraie copie certifiée du règlement A de la compagnie, tel qu'adopté par les directeurs, et approuvé par les actionnaires, le 18 août 1959.Le Secrétaire, 51537 FERNAND BOUCHARD.(P.G.12670-59) ARTISTS AND PHOTOGRAPHERS INC.Règlement N° 1,0 \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie \"Artists and Photographers Inc.\", ce qui suit: (A.G.122S4-56) LEMOYNE OIL CO.LTD.LA CTE D'HUILE LEMOYNE LTÉE By-law A A by-law to increase the number of directors.The number of directors of the company is increased from three to five and the by-laws of the company are amended accordingly.Certified true copy of by-law A of the company, as adopted by the directors and approved by the shareholders on August J8th, 1959.FERNAND BOUCHARD, 51537-o Secretary.(A.G.12670-59) ARTISTS AND PHOTOGRAPHERS IXC.Bylaw No.1,9 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Artists and Photographers Inc.\", as foMows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.38 3725 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présences, augmenté de trois Ci) à quatre (-1) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de (piatre (4) directeurs; 2 Quatre M) directeurs constitueront quorum à toute assemblée du bureau de direction; 3° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icclui, sont par les présentes, amendés, modifiés I revisés de manière à donner effet à ce règlement.\" Vraie copie certifiée du règlement N° 49 de 'Artists and Photographers Inc.\", lequel a été dûment décrété à une assemblée du bureau de direction de la compagnie, dûment tenue le 12e jour d'août 1959, et a été confirmé subséquent-ment par le vote unanime de tous les actionnaires de la compagnie, présents à une assemblée générale spéciale des actionnaires, le I2e jour d'août 1959.(Sceau) Le Secrétaire.51538 (Signé) SOL LIT.MAX.(P.G.1888-50) SHERATON HOTELS LIMITED Règlement 11-1) Un règlement qui augmente le nombre des directeurs de la compagnie de huit à neuf.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de huit à neuf et que le règlement X° 11 des règlements généraux de la compagnie tel qu'amendé par le règlement N° 11-C soit de nouveau amendé en conséquence.Vraie copie certifiée du règlement 11-1) de la compagnie \"Sheraton Hotels Limited\", lequel a été décrété à une assemblée du bureau de direction de la compagnie dûment tenue le 14c jour de juillet 1059, et a été sanctionné -uhséqueninieiit par au moins les deux tiers du vote des actionnaires de la compagnie déposé à une assemblée générale spéciale des actionnaires dûment convoquée aux fins de considérer ledit règlement, et tenue le même jour.Daté ce 25e jour d'août 1959.L'Assistant-secrétaire de (Sceau) Sheraton Hotels Limited.51539 R.E.PARSONS.AVIS PUBLIC Province de Québec - - District de Joliette Cour Supérieure.X° S358 Je, soussigné, donne avis que conformément à une ordonnance de la Cour supérieure du district de Joliette.rendue le 28 août 1959 par l'honorable C.E.Fcrland.J.C.S.la terre tie Paul Masse, cultivateur, de la paroisse de St-Thomas.comté de Joliette.sera vendue à l'enchère publique par Me J.1).Giroux, notaire préposé à la vente, à la porte de l'église de St-Thomas, comté de Joliette.SAMEDI le VINGT-QUATRE OCTOBRE 1959.à ONZE heures de l'avant-midi, savoir: \"Une terre située en la paroisse de St-Thomas.comté de Joliette et se composant tics lots numéros 440, 441.443 et 440 du cadastre officiel de la paroisse de St-Thomas et des lots numéros 167A, 10SA.1G9A et 170A du cadastre officiel de la paroisse tic Ste-Klisabeth.A distraire la partie appartenant à Hildège Masse acquise suivant acte enregistré à Joliette sous le numéro 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three (3) to four (4) so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of four ( I) directors; 2.Four (4) directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors; 3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" Certified to be a true copy of by-law No.19 of \"Artists and Photographers Inc.\", which was duly enacted at a meeting of the board of directors of the company duly held on the 12th day of August, 1959, and was subsequently confirmed by the unanimous vote of all the shareholders of the company present at a special general meeting of shareholders on the 12th day of August, 1959.(Seal) (Signed) SOL LI I'M AX.51538-o Secretary.(A.G.1888-50) SHERATON HOTELS LIMITED By-law 11-1) A by-law to increase the number of the company's directors from eight to nine.That the number of the company's directors be and the same is hereby increased from eight to nine and that by-law 11 of the general bylaws of the company as amended by by-law 11-C be further amended accordingly.Certified to be a true copy of by-law 11-1) of \"Sheraton Hotels Limited\" which was enacted at a meeting of the boa id of directors of the company duly held on the 14th day of July, 1959, and was subsequently sanctioned by at least two-thirds of the votes of the shareholders of the company cast at a special general meeting of the shareholders duly called for the purpose of considering such by-law held the same day.Dated this 251 h day of August.1959.R.E.PARSONS, (Seal) Assistant Secretary of 51539-0 Sheraton Hotels Limited.PUBLIC NOTICE Province of Quebec-\u2014 District of Joliette Superior Couit, Xo.8358 I, the undersigned, give notice that pursuant to an order of the Superior Court of the district of Joliette.rendered August 28.1959 by the Honourable C.E.Perland, J.S.C.the farm of Paul Masse, farmer, of the parish of St-Thomas.county of Joliette.shall be sold at public auction by Me J.1).Giroux, notary in charge of the sale, at the door of the church of St-Thomas.county of Joliette.SATURDAY the TWENTY-FOURTH day of OCTOBER 1959.at ELEVEN o'clock in the forenoon, to wit: \"A farm situate in the parish of St-Thomas.county of Joliette and composed of lots number 440.441, 443 and 440 of the official cadastre of the parish of St-Thomas and lots numbers 167A, 168A, 169A and 170A of the official cadastre of the parish of Ste-Elisabeth.Save and except that part belonging to Hildège Masse acquired according to deed registered at Joliette 372G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1969, Tome 91, N° 88 74082.Cette terre est bâtie de maison et dépendances mesure environ 213 arpents en superficie.\" Donné à St-Thomas ce quinze septembre 1959.J.I).(ilROUX.notaire.Berthiei ville, P.Q.51541-38-2-0 under number 74082.This farm includes a house and dependencies, and measures some 213 arpents in area.\" Given at St-Thomas this fifteenth day of September, 1059.J.I).GI ROUX, Notary.Berthierville, P.Q.51541-38 2 Bills - Assemblée législative AVIS DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Aux ternies du règlement, les bills privés devront être déposés avant le 28 octobre 1959 et présentés avant le 9 décembre 1959, les pétitions introductives de bills privés devront être présentées avant le 28 novembre 1959 et reçues avant le 3 décembre 1959, et les rapports de comités élus chargés de l'examen des bills privés devront être reçues avant le 23 décembre 1959.Québec, le 16 septembre 1959.Ixî Greffier de l'Assemblée législative, 51506-3S-0-o ANTOINE LEMTEUX.Hills - Legislative Assembly NOTICE OF LEGISLATIVE ASSEMBLY Concerning private bills which shall be intra, duced during the coining Session.According to standing orders, private hills shall be deposited before October 28.1959 and introduced before December 9, 1959, petitions for private bills shall be presented prior to November 28, 1959, and received prior to December 3, 1959, and reports from elected committees charged with the examining of private bills must be received before December 23, 1959.Quebec, September 10, 1959.ANTOINE LEMIEUX, 51506-38-9 Clerk of the Legislative Assembly.Chartes \u2014 Abandon de VINYL LINENS (CANADA) LTD.Avis est.par les présentes, donné que \"Vinyl Linens (Canada) Ltd.\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 14e jour d'août 1959.Le Secrétaire.51476 M.T.STARK.INTERNATIONAL FABRICS IXC.Avis est.par les présentes, donné (pie la compagnie \"International Fabrics Inc.\".constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Quebec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 9e jour de septembre 1959.Le Secrétaire.51487 SARAII MILLER.LIDO DEVELOPMENT CORPORATION Avis est par les présentes donné que \"Lido Development Corporation\", qui a son bureau principale dans le district de Montréal, province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies de Québec.Montréal, P.Q., le 14 septembre 1959.Le Secrétaire.PASCAL MOTAFFERI.Cerini & Jamieson, avocats & solliciteurs, Montréal, P.Q.51502-o Charters \u2014 Surrender of VINYL LINENS (CANADA) LTD.Notice is hereby given that \"Vinyl Linens (Canada) Ltd.\".a corporation constituted under the Quebec Companies* Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 14th day of August.1959.M.T.STARK.51470-o Secretary.INTERNATIONAL FABRICS INC.Notice is hereby given that \"International Fabrics Inc.\".incorporated under the Quebec Companies' Act.and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 9tb day of September, 1959.SARAH MILLER, 51487-o Secretary.LIDO DEVELOPMENT CORPORATION Take notice that \"Lido Development Corporation\", with head office in Montreal.Quebec, will apply for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, P.Q.September 14, 1959.PASCAL MOTAFFERI, Secretary.Cerini & Jamieson.barristers & solicitors, Montreal, P.Q.51502-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, September 19th, t959, Vol.91, No.88 CHAUSSURE LAÇASSE LIMITÉE Prenez avis que la compagnie \"Chaussure I.ruasse Limitée\" demandera au procureur général la permission d'abandonner sa charte.Le Procureur de la compagnie, 5151 l-o Me MAURICE MARTEL.MITCHELL HOLDINGS (1037) LIMITED Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \u2022Mitchell Holdings (1037) Limited**, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, en la province de Québec, ce I le jour de septembre 1959.Le Secrétaire, 51529 I.YOUNG.A L.MONT LIMITED Avis est.par les présentes, donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Ahnoni Limited\", s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, en la province de Québec, ce I le jour de septembre 1959.Ix- Secrétaire, 51530 I.YOUNG.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.537-59) ATLANTIC AIRLINE AND ELECTRONIC SCHOOLS, LTD.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Atlantic Airline and Electronic Schools, Ltd.\", une corporation à l'omis social étrangère constituée en vertu de \"The General and Business 1 orporation Act, Missouri 19-13\", ayant siège social en la cité de Kansas, état du Missouri.E.U.A., a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q.1911.chapitre 279.Le bureau principal de ladjte compagnie dans la province sera établi à l'Edifice AIdred, 507 Place d'Armes, en les cité cl district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les -signalions dans les procédures exercées contre elle, est M.Jerome C.Smyth, avocat et solliciteur, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce lie jour de septembre 1959.]a' Sous-secrétaire de la province.51471 RAYMOND DOUVILLE.3727 CHAUSSURE LAÇASSE LIMITEE Take notice that the company \"Chaussure Laçasse Limitée\", shall apply to the Attorney General for leave to surrender its charter.Me MAURICE MARTEL.51514-0 Attorney for the Company.MITCHELL HOLDINGS (1937) LIMITED Notice is hereby given that \"Mitchell Holdings (1937) Limited\", in cacordance with the Quebec Companies' Act.will apply to the Attorney General of the Provin.ee of Quebec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, in the Province of Quebec, this 11th day of September 195!).I.YOUNG, 5l529-o Secretary.ALMOMI LIMITED Notice is hereby given that \"Almomi Limited,\"' in accordance with the Quebec Companies' Act.will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, in the Province of Quebec, this 11 tli dav of September 1959.I.YOUNG, 51530-o Secretary.Company Licensed to do Business (P.Sec.537-59) ATLANTIC AIRLINE AND ELECTRONIC SCHOOLS.LTD.Notice is hereby given that \"Atlantic Airline and Electronic Schools, Ltd.\".an extra-provincial corporation incorporated in virtue of \"The General and Business Corporation Act, Missouri 1943\", with head office at the city of Kansas.Slate of Missouri, U.S.A.has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions ol* the Extra-Provincial Companies' Act.R.S.Q.1941.chapter 279.The principal office of the said company in the Province is to be established at Aldred Building, 507 Place d'Armes, in the city and judicial district of Montreal.Its chief ageid for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Jerome C.Smyth, barrister and solicitor, of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th dav of September, 1959.RAYMOND DOUVILLE, 51471-0 Assistant-Secretary of the Province.Compagnies dissoutes ' P.G.1151 1-59) 11 EL I, E El ,E I R CO N STR U ( TK )N CORP.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Belle Pleur Construction Corp.\", Companies Dissolved (A.G.11514-59) BELLE FLEUR CONSTRUCTION CORP.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender ol\" the charter ol\" the company \"Belle Fleur Construction Corp.\".incorporated under 3728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° 38 constituée en corporation en vertu de ladite première partie île la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date «lu 18 novembre 1955.tilt» Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un août 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté 'du bureau du Procureur général, le premier septembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51171-0 P.FRENETTE.(P.G.135(10-59) QUEBEC COAL & OÏL LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Qu'bec, Statuts refondus de Québec, 19-11.chapitre 27(1, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Quebec Coal & Oil Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Ix» des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 27 mai 1931.Avis est de plus donné qu à compter du quinze août 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept août 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51471-o P.FRENETTE.(P.G.13321-57) LA COMPAGNIE D'AQUEDUC DU VILLAGE DE LOTBINIÈRE Avis est donné (m'en vertu de la deuxième partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 127, et.sujet à la responsabilité décrétée par l'article 128 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de \"La Compagnie d'Aqueduc du Village de Lotbinière\", constituée en corporation le 28 septembre 1911.en vertu des dispositions de la section septième du chapitre troisième du Titre onzième des Statuts refondus de Québec, 1909, concernant les compagnies pour le gaz et l'eau.Avis est de plus donné qu à compter du trente et un août 195°, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier septembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.ERENETTE.(P.G.13180-58) ÉDIFICE DU DÉPÔT DENTAIRE DE MONTRÉAL INC.Avis est donné qu en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Edifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 30 octobre 1940.Avis est de plus donné qu à compter du trente et un août 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier septembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51471-0 P.FRENETTE.said Part I of the Quebec Companies' Act, ! letters patent dated November 18, 1955.Notice is also given that from and after the thirty-first day of August, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13500-59) QUEBEC COAL & OIL LIMITED Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, el 270.R.S.Q., 1911.and subject to the lia! |V enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Quebec Coal & Oil Limited\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 27, 1931.Notice is also given that from and after the fifteenth day of August, 1959.the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of August, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13321-57) LA COMPAGNIE D'AQUEDUC DU VILLAGE DE LOTBINIÈRE Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 127, chapter 270.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 128 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the sur» render of the charter of the company \"La Com pagnie d'Aqueduc du Village de Lotbinière\".incorporated September 28, 1911, under the provisions of section seven, chapter third of Title eleven of the Revised Statutes of Quebei 1909, concerning gas and water companies.Notice is also given that from and after the thirty-first day of August, 1959, the said com pany has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of September, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13180-58) ÉDIFICE DU DÉPÔT DENTAIRE DE MONTRÉAL INC.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 270, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Edifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.\", incorpora ted under said Part I of the Que1 ec Companies' Act, by letters patent dated October 30, 1940.Notice is also given that from and after the thirty-first day of August, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day of September, 1959.P.FRENETTE, 51471 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, I960, Vol.91, No.88 3729 Demandes à la Législature CONGREGATION SHOMRIM LABOKER-BETH YEIUDAII AM) A F FILIATED CONGREGATION SUA ARE TEFILLAH Avis public est par les présentes donné que Messieurs Robert Brel Isclineider, manufacturier, Phil Fainer, manufacturier, Ben Rochman, eut repreneur de transports, Sam Eisman, marchand, David Phillips, opérateur, Louis Eisman, marchand, Moses Lewis, manufacturier, Larry Silverman, comptable, .Moses Labensohn, contremaître, Louis Bist risky, manufacturier, Ben Fcldmah, épicier, Hyman Fleisher, Loucher, Samuel Labensohn, secrétaire, Joseph A.Mendelsohn, avocat, Abe Zinman, fourreur, Solomon (iitlitz, marchand, Lazarus Robin, marchand, Solomon Kaufman, marchand, Max Katz, marchand, David Kaufl'nian, rentier, Hyman Lécher,-rentier, Arthur Tabac, agent d'achats, Harry Kolher, notaire, et Nathan Nathanson, contrôleur, tous de la cité et du district de .Montréal, s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi les incorporant, eux et d'autres qui, ultérieurement, pourraient en devenir membres, en une congrégation religieuse connue sous le nom de \"Congregation Shomrim Laboker-Bcth Yehudah and Affiliated Congregation Shaare Tefillah\", avec le droit (t le pouvoir d'acquérir et de posséder des biens immobiliers requis pour une synagogue ou maison du culte, pour une résidence de rabbin ou de ministre du culte, pour un cimetière ou terrain d'inhumation; de vendre, louer, échanger, hypothéquer ou aliéner les biens de la congrégation ou toute partie de ceux-S ci et d'acquérir d'autres biens immobiliers à la™ place de ceux-ci; de libeller, faire accepter et endosser pour les propres fins de la congrégation, lettres de change, billets promisse ires et autres effets négociables, sous la signature de ses officiers, ou d'autres que pourrait désigner sen conseil d'administration; de tenir des registres pour les actes de statut civil; de nommer de temps à autre un rabbin ou des rabbins ou un ministre ou des ministres du culte; de le ou les démettre et d'en nommer un ou d'autres à sa ou à leur place; ledit rabbin ou lesdils rabbins et/ou le ou les ministres du culte de la congrégation auront autorité et pouvoir de tenir dés registres pour les actes de statut civil et d'exercer, relativement à cela, tous les autres pouvoirs civils pertinents aux ministre s des congrégations religieuses; le ou les rabbins, le ou les ministres de culte n'ayant pas besoin d'obtenir un permis du gouverneur ou d'une personne administrant le gouvernement, tel que décrété dans la loi de l'ancienne province du Bas-Canada, 9-10, George IV, ch.75.et possédant néanmoins tous les pouvoirs conférés par ladite loi sur les ministres ainsi licenciés; et de prendre l'actif et le passif des corporations \"Congregation Shomrim .Laboker-Bcth Yehudah\" et \"Congregation Shaare Tefillah\", toutes deux déjà dûment incorporées par loi privée, le tout avec le consentement desdites corporations.Montréal, 0 août 1959.Le Procureur pour les requérants, 51332-35-4-0 ISIDORE POPLIGER, C.R.Applications to Legislature CONGREGATION SHOMRIM LABOKER-BETH YEHUDAH AND AFFILIATED CONGREGATION SHAARE TEFILLAH Public notice is hereby given that Messrs.Robert Brettschneider, manufacturer, Phil Fainer, manufacturer.Ben Rockman, transporter, Sam Eisman, merchant, David Phillips, operator, Louis Eisman.merchant, Moses Lewis, manufacturer, Larry Silverman, accountant, Moses Labensohn, foreman, Louis Bistrisky, manufacturer, Ben Feltlman, grocer, Hyman Fleisher, butcher.Samuel Labensohn, secretary, Joseph A.Mendelsohn, lawyer, Abe Zinman, furrier, Solomon Gitlitz, merchant, Lazarus Robin, merchant, Solomon Kaufman, merchant, Max Katz.merchant, David Kauffman, retired, Hyman Lecker, retired, Arthur Tabac, purchasing agent, Harry Kilber, notary, and Nathan Nathanson, comptroller, all of the city and district or Moid real, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session, for the passing of an Act incorporating them and such others as may hereafter become members, into ii religious Congregation under the name of \"Congregation Shomrim Laboker-Beth Yehudah and Affiliated Congregation Shaarc Tefillah\", with the right and power to acquire and hold immoveable property which may be required for a Synagogue or place of worship, for a residence for a Rabbi or officiating minister, for a cemetery or burial ground; to sell, lease, exchange, hypothecate or alienate its property or any part thereof, and acquire other immoveable property liu lieu thereof; to draw, make, accept and endorse 'l'or its own purpose, bills of exchange, promissory notes and other negotiable instruments under the signature of its officers or others as may be determined by its board of directors; to keep registers for acts of Civil Statuts; to appoint from time to time, a Rabbi or Rabbis or officiating Minister or Ministers, and to remove him or them, and appoint another or others in bis or their place, the said Rabbi or Rabbis and/or officiating Minister or Ministers of the Congregation to have authority and power to keep registers for acts of Civil Status, and to exercise in relation thereto, all other civil powers pertaining to ministers of religious congregations; such Rabbi or Rabbis arid/or officiating Minister or Ministers shall not need to obtain a license from the Governor or person administering the Government as enacted in the act of the late Province of Lower Canada, 9-10, George IV, ch.75, and shall nevertheless have all the powers conferred by the said act on Ministers so licensed; and to take over the assets and liabilities of the corporations of the \"Congregation Shomrim-Labokcr-Bcth Yehudah\" and \"Congregation Shaare Tefillah\", both already duly incorporated by private act, the whole with consent of the said corporations.Montreal.August 0.1959.ISIDORE POPLIGER, Q.C., 51332-35-4-0 Attorney for the petitioners.THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED Avis public est par les présentes donné que \"The Steel Company of Canada, Limited\", se présentera à la législature de la province de THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED Public notice is hereby given that \"The Steel Company of Canada, Limited\", will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its 3730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome OL N° 88 Québec lors de sa prochaine session afin de faire passer une loi déclarant valides et légaux certains titres, de propriété immobilière et ratifiant des conventions entre ladite compagnie et la corporation de la paroisse de Contrecoeur ainsi que Les commissaires d'écoles «le la municipalité de Contrecoeur, du comté de Ycrclièrcs.Les Procureurs de la requérante, HEWARD, HOLDEN, HUTCHISON, CUFF, McMASTER & MEIGHEN.51405-36-4-o GAZ NATIONAL INC.NATION A CAS INC.Avis est par les présentes donné que \"Caz National Inc.- National Gas Inc.\" s'adressera à la Législature de la province de Québec à sa prochaine session pour l'adoption d \"une loi l'autorisant : 1° A acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous droits de passage, servitudes et terrains nécessaires pour la construction de pipelines pour la transmission et la distribution du caz naturel dans les comtés «le: Napiervillc-Laprairie, St-Jean, Iberville, Rouville, Missis- (pioi.Shell'ord.St-Hyacinthc, Richelieu.Druin- mond, Richmond.Sherbrooke, Compton, Nicole), Trois-Rivières, Champlain.Sl-Mauriee, La-violctle.moins le territoire déjà prévu dans le chapitre 157 des Statuts refondus de la province de Québec \u2022!-\"> Elizabeth II, tel que modifié; 2° A acquérir, de gré à gré.tout système de distribution de gaz avec toutes franchises, droits de passage cl servitudes s'y rattachant et à les exercer: et 3° A exercer dans les limites du territoire susdit les pouvoirs énoncés dans les articles 63 à 71 et 73 à 7(i inclusivement de la Loi des compagnies de Gaz et d'Eau (S.R.Q.1941, ch.294).Moid real.P.Q., le 9 septembre 1959.Les Procureurs de la Petitionnajrc, COMMON.HOWARD.CATE, OGILVY, BISHOP, COPE, 51454-37-4-0 PORTEOUS & HANSARD.LA MUTUELLE DES COMMISSIONS SCOLAIRES.COMPAGNIES D'ASSURANt ES ( ; EN ERALES Avis est par les présentes donné (pie: MM.Paul Desrochers, Gérard Amplcman.Albert Mo-rissette.Auguste Scott.Roland Tbéorèt.Léonard Morin, Gabriel Lemire, Roland Leroux, Wilbrod Dufour, Albert Oucllct et Camille Lavoie, tous membres de commissions scolaires faisant partie de la Fédération des Commissions Scolaires Catholiques du Québec, vont demander à la prochaine session de la législature de Québec qu'une société mutuelle d'assurances générales soit incorporée, ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance et «le réassurance mutuelles, sous le nom de, en français, \"La Mutuelle des Commissions Scolaires, Compagnie d'Assurances Générales\" et, en anglais.\"The School Commissions Mutual General Insurance Company\".Montréal, ce 8 septembre 1959.JEAN-PAUL VERSCHELDEN C.R.ôlô avenue Viger, ch.101.51456-37-4-0 Montréal.Que.COMMISSAIRES D'ÉCOLES POUR LA MUNICIPALITÉ DE LES MÉCHINS Avis public est par les présentes donné que les 'Commissaires d'Ecoles pour la Municipalité de next session for the passing of an Act to declare valid and legal certain titles of immoveable properties and to ratify agreements passed by the said company with the corporation of the parish of Contrecoeur and The school commissioners for the municipality of Contrecoeur, in the couidv of VercJières.HEWARD.HOLDEN, HUTCHISON.CLIFF.McMASTER & MEIGHEN, Attorneys for Petitioner.51405-36-4-o GAZ NATIONAL INC.NATIONAL GAS INC.Notice is hereby given that \"Gaz National fnc.National Cas Inc.\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session for the adoption of an Act authorizing it : 1.To acquire by mutual agrccmenl or bj expropriation rights-of-way, servitudes and lands necessary for the construction of pipelines for the transmission ami distribution of natural : in the counties of: Napierville-Laprairic, ' John, Iberville, Rouville, Missisquoi, Shcfford, St.Hyacinthe.Richelieu.Drummond.Rich inond, Sherbrooke, Compton.Nieolet, Three Rivers.Champlain, St.Maurice, Laviolettc, less any part of said counties which may be included in the territory referred to in chapter 157 of the Statutes of Quebec 4-5 Elizabel h 1L as amended 2.To acquire by.mutual agrccmenl any system of gas distribution with all franchises, rights-of-way and servitudes connected therewith and to exercise the same; and 3.To exercise in the aforesaid territory the powers specified in sections 63 to 71 and 73 to 7(> inclusive of the Gas and Water Companies' Act (R.S.Q.1941, ch.294).Montreal.P.Q., September 9th, 1959.COMMON.HOWARD.CATE.OGILVY, BISHOP.COPE.PORTEOUS & HANSARD.51454-37-4-0 Attorneys for Petitioner.THE SCHOOL COMMISSIONS MUTUAL GENERAL INSURANCE COMPANY Notice is hereby given that: M.Paul Dcsro-chers, Gérard Amplcman, Albert Morissette, Auguste Scott.Roland Thcorét, Léonard Morin, Gabriel Lemire, Roland Leroux.Wilbrod Dufour.Albert Ouellel septembre 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique.ÔI527-0 O.1.DÉSAULNIERS.Department of Education No.s;.-,.')!).SCHOOL MUNICIPALITY OP ST-JEAN-BAPTISTE-DE-MONTR ÉAL-SUD Application is made to change the name of the School Municipality of St-Jean-Baptiste-de-Montréal-Sud, in the county of Chambly, to that (>r Montreal-South, same county.Quebec, September II, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 51525-38-2 Superintendent of Education.No.722-59.SCHOOL MUNICIPALITY OF LES SAULES His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council No.858 under date of the first day of September, 1959, to change the name of the School Municipality of Ste.Monique-des-Saulcs, in the county of Quebec to that of Les Saules, same county.This change shall take effect September 27.1959.Quebec, September 16, 1959.O.1.DÉSAULNIERS.51527 Superintendent of Education.NO.348-58.SCHOOL MUNICIPALITY OF GRACEFIELD His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council, dated the first day of September 1959, to annex, for Catholic ratepayers only, the present territory «d' the School Municipality of Northfield, in the county of Gatineau to that of the Yillagc of Graceficld, same county, and to change the name of the latter to that of \"School Municipality of Gracefield, in the county of Gatineau.\" These changes shall take effect on the first day of July I960.Quebec.September 16, 1959.O.J.DÉSAULNIERS.51527 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS I adastre officiel du canton de Letellier (municipalité de ville des Sept-Iles) division d'enregistrement de Saguenay.Avis est par la présente donné qu'une partie «les lots 494.197.498 et 199 du rang IL village Department of Land and Forest NOTICE Official cadastre of township of Letellier (municipality of town of Sept-Iles) registration division of Saguenay.Notice is hereby given that a part of lots 494.197.498 and 199.\" range 11.village des Sept-Res, 3732 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1969, Tome 91, N° 88 des Sept-Iles est annulée et les lots 2140 à 2351 sont ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 août 1050.Le Département des Terres et Furets.Service du ( 'adiistrc.I.e Sous-ministre.51472-o A VILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de la Victoire (municipalité de cité de Levis, quartier Villemay).division d'enregistrement de Lévis.Avis est par la présente donné que les lots 257-3 à 257-24 et qu'une partie des lots 257-25, 257-20.257-29, 257.-330.331.50S et une partie de la rue St-Edouard sont annulés et le lot 603 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 août 1059.Le Département des Terres et Forêts.Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 51475-0 AVI LA BÊDARD.Cadastre officiel d'une partie du canton «le Aulneau division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que les blocs A-l et A-2 sont annulés et les blocs A, C, D sont ajoutés en vertu de 1'arlicle 2174A du Code civil.Québec, le 11 septembre 1959.Le Département des Terres et Forêts.Service du Cadastre.Le Sous-ministre, 5l472-o A VILA BÊDARD.Cadastre officiel du canton de Bégin division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné «pie le bloc \"A\" est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 11 septembre 1959.Le Département des Terres et Forêts.Service du Cadastre.Le Sous-ministre.5l472-o A VILA BÊDARD.Cadastre officiel «lu canton de Dalinas (municipalité de Péribonca) division d'enregistrement de Lac St-Ican-Ouest.Avis est par la présente donné que les blocs A et B sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 11 septembre 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre.Le Sous-ministre, 51472-0 AVILA BÊDARD.Cadastre officiel du canton de Gamier division d'enregistrement de Lac St-Jean-Est.Avis est par la présente donné que les blocs A, B et C sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 11 septembre 1959.Ix?Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre.Le Sous-ministre, 51472-0 AVILA BÊDARD.has been cancelled and lots 2140 to 2351 are added in virtue of Article 2174A of the Civil ( 'ode.Quebec.August II.1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÊDARD, 51472-0 Deputy-Minister.Official cadastre of the parish of Notre-Dame dc la Victoire (municipality of City of Levis, Villcmay Ward) registration division of lévis.Notice is hereby given that lots 257-3 to 25\" 24 and a part of lots 257-25, 257-2(i, 257-29, 257, 330, 331.598 and a part of St-Édouard are cancelled and lot 603 has been added in virtue of Article 2171A of the civil ocde.Quebec.August 24, 1959.Department of Lands and Forests, ( ïadastral Branch, AVILA BÊDARD.51472-0 Deputy-Minister.Official cadastre of a part of township of Aulneau registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that blocks A-l ami 2 are cancelled ami blocks A, C.1) are added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec.September 11.1959.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch.AVILA BÊDARD.51 l72-o Deputy Minister.Official cadastre of township of Bt'-gin registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that block \"A\" has been added in virtue of article 2174A of tin-Civil Code.Quebec.September II.1959.Department of Lands and Forests.( 'adasl ral Branch, AVILA BÊDARD, 51472-0 Deputy Minister.Official cadastre of township of Dalmas (municipality of Péribonca) registration division of Lac St-Jcan-Ouest.Notice is hereby given that blocks A ami H are added in virtue of article 2I74A of the ( 'ivil ( 'ode.Quebec, September II.1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÊDARD, 51472-0 Deputy .Minister.Official cadastre of township of (minier registration division of Lac St-Jean-Est.Notice is hereby given that blocks A.B and C are added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, September II, 1959.\u2022 Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 51 172-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September li)th, 1959, Col.91, No.3S 3733 i adastre officiel du canton deLabrecquc,division d'enregistrement de Clùcoutimi.Avis est par la présente donné que les lots 34-a, 34-6, 35-a, 35-6, 36-a, 36-6, 36-c, 37-o, 37 b, 37-r, 38-a.38-6, 38-c, 38-d, 39-a, 3!)-/;, 40-a, -10-/;.10-e.41-,/.11-/;.41-c, 42-a, 42-6, 13-a, 43-/;.44-a, 44-6, 45-a, 45-6, 46-a, 46-6, 17 \\ Notice is hereby given that \"Sparta Development Corporation\", incorporated by letters patent under the provisions of Fart I of the Quebec Companies' Act on the 1st day of March, 1959, and having its head office in the city and «listrict of Montreal, has eatablished its office at suite 103, 5.950 Côte des Neiges.Montreal, Que.Dated at Montreal, this 7th day «>f July, 1959.DAVE WHITE, 51481-0 Secretary.SIDEPAL CORF.Avis est, par les présentés, donné «pie la compagnie \"Si«lepal Corp.*', constituée en vertu des «lispositions «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, le 9e jour de juin 1959, et ayant son si«>gc social en la cité «le Montréal, en lad'te province, a établi son bureau à 2,425 Lafortune Circle, St-Laurent, Québec.A compter de la date «le cet avis, ledit bureau sera consuléré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 10e jour de septembre 1959.Le Pr«\\si«lent, 51482 MYER LA PEDIS.SIDEPAL CORP.Notice is hereby given that \"Sidcpal Corp.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 9th day of June, 1959, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 2.425 Lafortune Circle, St.Laurent.Quebec.From and after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 10th day of September, 1959.MYER LAPEDIS.51482-0 President.(P.G.10770-59) CUSSON FRÈRES GENERAL CONTRACTORS LTD.Règlement A'° 4{ \"Qu'il soit décrété «pie la situation du bureau chef de la compagnie soit changée «lu numéro civique 660S rue Jeanne Mance, en la cité de Montréal, son adresse antérieure, au numéro civique 454 Roulevard Reaconsfield, en la ville de Beaconsfield, province de Québec.\" Certifié vraie copie du règlement N° 24 de la compagnie \"Cusson Frères General Contractors Ltd.\", qui a été adopté par son bureau de direction à une assemblée tenue le 6 avril 1959 et approuvé par tous les actionnaires de la compagnie à une assemblée générale et spéciale tenue à la même date.Reaconsfield.le 8 avril 1959.Le Secrétaire, 51483-o R.CUSSON.WASYLYKS LTD- Avis est, par les présentes, donné «pie le siège social de \"Wasylyks Ltd.\", une compagnie constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes en date «lu 10 mai 1955, est situé à 105 avenue Carter, en la cité de No-randa, province de Québec.Daté j\\ Noranda, P.Q.le 4 septembre 1959.Le Président, 514M4 PETER WASYLYK.(A.G.10770-59) CUSSON FRÈRES GENERAL CONTRACTORS LTD.By-law No.24 \"Be it enacted that the location of the head office of the company be moved from civic number 0608 of Jeanne Mance Street, in the city of Montreal, were it formerly was, to civic number 454 of Reaconsfield Roulevard, in the town of Beaconsfield, Province of Quebec.\" Certifie«l to be a true copy of by-law No.24 of \"Cusson Frères General Contractors Ltd.\", which was adopted by its board of directors at a meeting held on the 6th day of April, 1959, and approved by all the shareholders of the company at a general and special meeting held on the same date.Reaconsfield.the 8th April, 1959.R.CUSSON, 51483-o Secreta ry.WASYLYKS LTD.Notice is hereby given that the head office of \"Wasylyks Ltd.\", a company incorporated under the Quebec Companies' Act, Part I, by letters patent dated May 10th, 1955, is situate at 105 Carter Avenue, in the city of Noranda.Province of Quebec.Dated at Noranda, P.Q., on September 4th, 1959.PETER WASYLYK.51484-o President. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th.1959, Vol, 91, No.38 3747 (P.G.15131-59) CHARLES E.FROSST & CO.Règlement s]>écial \"G\" Qu'il soit, et il est, pur les présentes, décrété ce qui suit: Le siège social et principale place d'affaires de la compagnie est, par les présentes, transporté de la cité de Montréal à la cité de Westmount, m la province de Québec.Vraie copie certifiée.Montréal.P.Q., 14 septembre 1959.(Sceau) Le Président, JOHN B.FROSST.Le Secrétaire, 51515 CHAULES E.FROSST.MARSH INVESTMENTS LTD.Avis est, par les présentes, donné (pie la compagnie \"Marsh Investments Ltd.\" constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie do la Loi des Compagnies de Québec, le 30e jour do décembre 195S, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 5400 rue Hoclielaga.Montréal.Quélwc.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 10e jour «le septembre 1959.(Sceau) Ix* Secrétaire, 51510 SYDNEY CAPLAN.MAJESTIC INVESTMENT LTD.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Majestic Investment Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions «le la première partie «le la Ix>i des compagnies «le Québec, le 12e jour de mai 1959.et ayant son siège social en la cité «le Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 3600 avenue Van Horne.A compter «le la «late «le cet avis, le«lit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 17e jour de juin 1959.(Sceau) Ixî Secrétaire.51517-o KHEDOURI LA WEE.(A.G.15131-59) CHARLES E.FROSST & CO.Special by-law \"G\" Re and it is hereby enacted as follows: The head office and chief place of business of the company is hereby changed from the city of Montreal to the city of Westmount, in the Province of Quebec.Certifie»! true copy.Montreal.P.Q.September 14, 1959.(Seal) JOHN R.FROSST, President.CHARLES E.FROSST, 51515 -o Sécréta r y.MARSH INVESTMENTS LTD.Notice is hereby given that \"Marsh Investments Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act, on the 30th day of December 195S and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 5100 Hochelaga Street.Montreal.Quebec.From and after tin* date of this Notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at the city of Montreal, this 16th day of September.1959.(Seal) SYDNEY CAPLAN, 51516-o Secretary.MAJESTIC INVESTMENT LTD.Notice is hereby given that \"Majestic Investment Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 12th day of May, 1959, and having its head office in the city of Montréal, in the said Province, has established its office at 3000 Van Home Avenue.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 17th day «>f June, 1959.(Seal) KHEDOURI LAWEE, 5l517-o Secretary.GLADIOLI INVESTMENT LTD.- Avis est, par les présentes, donné «pie la compagnie \"Gladioli Investment Ltd.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, le 12e jour de mai 1959, et ayant son siège social en la cité «le Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 3600 avenue Van Horne.A compter «le la «late de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité «le Montréal, ce 17c jour de juin 1959.(Sceau) Le Secrétaire, 51518 KHEDOURI LAWEE.GARLAND INVESTMENT LTD.Avis est, par les présentes, donné «pie la compagnie \"Garland Investment Inc.\", constituée en corporation en vertu «les dispositions «le la GLADIOLI INVESTMENT LTD.Notice is hereby given that \"Gladioli Investment Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 12th day of May, 1959, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 3600 Van Horne Avenue.From and after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Datetl at the city of Montreal, tliis 17th day .of June.1959.* (Seal) KHEDOURI LAWEE, 51518-0 Secretary.GARLAND INVESTMENT LTD.Notice is hereby given that \"Garland Investment Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 3718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 19 septembre 1969, Tome 91, N° 88 première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 12e jour de mai 1959, et ayant son siège soeial en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 3600 avenue Van Home.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie connue étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 17e jour de juin 1959, (Sceau) Le Secrétaire.51519 KHEDOURI LAWEE.DORLY INVESTMENT LTD.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Dorly Investment Ltd.*', constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 12e jour de mai 1959, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 3600 avenue Van Horne.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 17c jour de juin 1959.(Sceau) Le Secrétaire, 51520-o KHEDOURI LAWEE.SANS SOUCI INVESTMENT LTD.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Sans Souci Investment Ltd.\".constituée en corporation en vertu des dispositions «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, le 12e jour de mai 1959.et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 3600 avenue Van Horne.A compter de la date «le cet avis, le«lit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité «le Montréal, ce 17e jour de juin 1959.(Sceau) Le Secrétaire, 51521 KHEDOURI LAWEE.12th day of May, 1959, ami having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 3(KM) Van Horne Avenue.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 17th dav of .bine.1959.(Seal) KHEDOURI LAWEE.51519-0 Secretary.DORLY INVESTMENT LTD.Notice is hereby given that \"Dorly Investment Ltd.\".incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 12th day of May.1959, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 3000 Van Horne Avenue.From and after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office «'f the company.Dated at the city of Montreal, this 17th dav of June, 1959.(Seal) KHEDOURI LAWEE.5I520-o Secretary.SANS SOUCI INVESTMENT LTD.Notice is hereby given that \"Sans Souci Investment Ltd,.\", incorporated un«ler the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 12th day of May, 1959, am! having its hea«l office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 3600 Van Horne Avenue.From ami after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, tins 17th day «>f June, 1959.(Seal) KHEDOURI LAWEE, 5l521-o Secretary.EASTERN MILK CONCENTRATES LTD.Avis est donné «pie la compagnie \"Eastern Milk Concentrates Ltd.\", constituée en corporation en vertu «les dispositions de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, en date du 18 mars 1959 et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 3 est, rue Notre-Dame.A compter de la «late du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, le 27 juillet 1959.(Sceau) Le Secrétaire, 51540-o VIOLETTE ALLIE.EASTERN MILK CONCENTRATES LTD Notice is given that, the company \"Eastern Milk Concentrates Ltd.\".constituted as a corporation under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act, under «late of March 18, 1959.and having its head office in the city of Montreal, has established its office at number 3 Notre-Dame Street, East.From ami after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, July 27, 1959.(fed) VIOLETTE ALLIE.51540 Secretary.Soumissions LES COMMISSAIRES D'ECOLES POUR LA MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE BELOEIL (( 'onité de Verchères) Avis public est, par les présentes, donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le sous- Tcndcrs THE SCH(K)L COMMISSIONERS FOR THE MUNICIPALITY OF THE TOWN OF BELOEIL (County of Verchères) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Ronds\" will be received by the undersigned Daniel Beauregard, Secre- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, X.88 3749 signé Daniel Beauregard, secrétaire-trésorier, 740 rue Laurier, Beleoil, comté de Verchères, jusqu'à K.00 heures du soir, jeudi, le 8 octobre 1959, pour l'achat de $410,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Beloeil.comté de Verchères, datées du 1er septembre 1959 et remboursables par séries du 1er septembre I960 au 1er septembre 1971 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5% ni supérieur à 6% par année, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Ix> taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 17 juin 1959 \u2014 construction d'une annexe à l'école secondaire SI-Mathieu.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul «l'intérêt sera fuit à compter du 1er novembre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $410,000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1 er septembre 1960.xS48,5()0.00 1er septembre 1901.x 51,000.00 1er septembre 1902.x 54,000.00 1er septembre 19(53.x 57,000.(X) Isr septembre 1904.x 00,000.00 1 cr septembre 1965.11,000.00 I er septembre 1966.11,500.00 1er septembre 1907.12.000.00 1 er septembre 1908.12,500.00 1 er septcml>re 1909.13,500.(H) 1er septembre 1970.14,000.00 I er septembre 1971.15,000.00 1er septembre 1972.16,000.00 1 er septembre 1973.16,500.(K) 1er septembre 1974.17.500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de §262,-100.00.accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $52,480.00 chacun, «le 1960 à 1904 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour «les obligations à courte échéance dix ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des deux termes.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bclccil.conté «le Verchères.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province «le Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er septembre 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, ou avant le 1er septembre 1967 inclusivement si elles sont émises pour le terme «le quinze ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 «les Statuts réfondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance «l'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée «l'un chèque accepté égal à 1% «lu montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment «le leur livraison.tary-Treasurer, 740 Laurier Street, Beloeil, county of Verchères, until 8.00 o'clock p.m., Tursday October 8.1959, for the purchase of §410,000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of the town of Beloeil, county of Verchères, dated September 1st, 1959, and re«lce-inable serially from September 1st 1900 to September 1st.1974 inclusively, at a rate of not less than 5% nor more than 0% per annum, payable .semi-annually, on March 1st, and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution dated .bine 17, 1959 \u2014 erection of an annex to the St.Mathieu school for secondary studies.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from November 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 H10.000.00 \u2014 15 years Year Capital September 1st, I960 .x$48,500.00 September 1st.1961 .x 51.000.00 September 1st, 1902 .x 54,000.00 September 1st, 1963 .x 57,000.00 September 1st, .1904 .x 60.000.00 September 1st.1965 .11.000.(X) September 1st.1966 .11.500.00 September 1st.1907 .12,000.00 September 1st, 1908 .12,500.00 September 1st, 1909 .13,500.00 September 1st.1970 .14,000.00 September 1st.1971.15,000.00 Sepgembcr 1st, 1972 .16,000.00 September 1st, 1973 .10,500.00 September 1st.1974 .17,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $262,400.00 granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of $52,480.00 each, from I960 t«> 1964 inclusively, will be received and applied to the service of the said loan.Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered for ten-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the two terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, princip il and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Beloeil, County of Verchères.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior t«> September 1st.1906, inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to September 1st, 1907 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, after which dates, the said bonds may, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of matiruty and serial numl>er.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender. 3750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.19 .septembre 1959.Tome 91.N° 38 Ix-s soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le S octobre 1959, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville.Beloeil.comté de Verchères.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Beloeil, (Comté de Verchères).ce 15 septembre 1959.l.e Secrétaire-trésorier, DANIEL BEAUREGARD.Adresse postale: Hôtel de Ville.C.P.500, Beloeil.(Verchères).P.Q.Téléphone: EOrêt 7-4669.51507-O The tenders will be opened ami considered at a meeting of the School Commissioners to be held on October 8, 1959, at 8.00 o'clock p.m.at the City Hall.Beloeil, County of Verchères.The School Commissioners do not bind them selves to accept the highest or any of the tenders Beloeil, (County of Verchères), this September 15.1959.DANIEL BEAUREGARD, Secretary-Treasu rer.Post Office Address: City Hall, P.B.500.Beloeil.(Verchères), P.Q.Telephone: EOrct 7-4669.51507 VILLE DE PLESSISVILLE (Comté de Mégantic) Avis public est par les présentes donné (pie des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné.Gilles Chabot, secrétaire-trésorier.Hôte] de Ville, 1760 rue St-Calixte, Plessisvillc.comté do Mégantic.jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 6 octobre 1959, pour l'achat de 8250.000.00 d'obligations de la ville de Pléssisville, comté de Mégantic, datées du 1er août 1959 et remboursables par séries du 1er août 1900 au 1er août 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5% ni supérieur à 6% par année, payable semi-annuellement les 1er février et 1er août (le chaque année.Ix- taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt No.315-V \u2014 construction d'une usine d'épuration pour les égouts.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er novembre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau (Tamorti.sscment \u2014 $200.000.00 \u2014 20 an.s Année Capital 1er août 1960.S 2.000.00 1er août 1961.2,000.00 1er août 1962.2.000.00 1er août 1963 .2.000.00 1er août 1964.2.000.00 1er août 1965.2.500.00 1er août 1966.2.500.00 1er août 1967.«.2.500.00 1er août 1968.3.000.00 1er août 1969.3.000.00 1er août 1970.3.000.00 1er août 1971.3.500.00 1er août 1972.3.500.00 1er août 1973.3,500.00 1er août 1974.4.000.00 1er août 1975 .4,000.00 1er août 1976.4.500.00 1er août 1977.4,500.00 1er août 1978.5,000.00 1er août 1979.191,000.00 De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Pléssisville, comté de Mégantic.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec TOWN OE PLESSISVILLE (County of Mégantic) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\", will he received by the undersigned, (idles Chabot.Secretary-Treasurer, City Hall, 1760 St.Calixtc Street.Plessisvillc, county of Mégantic, until 8.00 o'clock p.m.Tuesday, October 6, 1959, for the purchase of 8250.000.00 of bonds of the town of Plessisvillc, county of Mégantic, dated August 1st.1959.and redeemable serially from August 1st, 1960 to August 1st.1979 inclusive!,} at a rate of not less than 5% or more than ft', per annum, payable semi-annually, on February 1st and August 1st.of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.315-V \u2014 building of a filtration plant for sewers.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from November 1st.1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption $250.000.00 \u2014 20 years-Year Capital August 1st.1960.8 2.000.00 August 1st.1901.2,000.00 August 1st.1962.2,000.00 August 1st.1903.2.000.00 August 1st.1964.2.000.00 August 1st, 1965 .2.500.00 August 1st.1966.2.500.00 August 1st, 1967 .2,500.00 August 1st, 196S.3.000.00 August 1st.1969.3,000.00 August 1st, 1970 .3,000.00 August 1st.1971.3,500.00 August 1st, 1972 .3.500.00 August 1st, 1973.3,500.00 August 1st, 1974.4.000.00 August.1st, 1975.4.000.00 August 1st, 1976.4,500.00 August 1st, 1977.4,500.00 August 1st, 1978 .5,000.00 August 1st, 1979.191,000.00 Moreover, tenders may l>e forwarded and shall be considered for ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Plessisvillc.county of Mégantic.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank QUEBEC OFFIVIAL GAZETTE.Quebec.September 19th.1959.Vol.91.So.88 3751 de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas (-achetables par anticipation avant le 1er août 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er août 1907 inclusivement si elles sont ('¦mises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er août 1909 inclusivement si elles sont émises à courte échéance vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend pu ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Los soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui scia tenue mardi, le 6 octobre 1959, à S.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, 1700 rue St-Calixle, Plessisbille, comté de Mégantic.Le consei) se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pléssisville, (Comté de Mégantic), ce 15 septembre 1959.Le Secrétaire-trésorier, GILLES CHABOT.Adresse postale: Hôtel de Ville, CP.163, 1760 rue St-Calixtc, Pléssisville.Téléphone: 155.51508-o mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to August 1st, 1960 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to August.1st.1907 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, and prior to August 1st.1909 inclusively, if issued for a twenty-year term, after which dates the said bonds may.under the authority of chapter 212.Revised Statutes of Quebec 1941.be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par.at any interest maturity date, however, in ease of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to \\% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at.a meeting of the Council to be held on Tuesday.October 6, 1959.at 8.00 o'clock p.m., at the City Hall.1760 St.Calixte Street.Plessisvillc.county of Mégantic.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Plessisvillc, (County of Mégantic).this September 15.1959.GILLES CHABOT, Secretary -Treasurer.Post Office Address: City Hall.P.P.163, 1760 Calixte Street, Plessisvillc.Telephone: 155.51508 LES COMMISSAIRES D'ÉCOLES POUR LA MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE LA TUQUE (Comté de Ixvviolette) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le sous-signé Henri Légaré, secrétaire-trésorier, 376 rue St-Joseph, Im Tuque, comté de Laviolette, jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 6 octobre 1959, pour l'achat de 8185,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de I^a Tuque, comté de Laviolette, datées du 1er septembre 1959 et remboursables par séries du 1er septembre 1900 au 1er septembre 1979 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5% ni supérieur à 6% par année, payable semi-annuellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 13 juillet 1959, telle que modifiée \u2014 agrandissement de l'école centrale.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er novembre 1959.Le tableau d'amortissement, est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $185,000.00 \u2014 20 ans Année 1er septembre 1965 1er septembre 19(56 1er septembre 1967 1er septembre 1968 \tCapital .x\t$15,500.00 .x\t16,500.00 .x\t17,500.00 ,.x\t18,500.00 \t19,500.00 \t4,500.00 \t4,500.00 \t5,000.00 \t5,000.00 THE SCHOOL COMMISSIONERS FOR THE MUNICIPALITY OF THE TOWN OF LA TUQUE (County of Laviolette) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Henri Légaré, Secretary-Treasurer, 37(5 St.Joseph Street, La Tuque, county of Laviolette, until 8.00 o'clock p.m., Tuesday, October (5, 1959, for the purchase of 8185.000.00 of bonds of the school commissioners for the municipality of the town of La Tuque, county of Laviolette.dated September 1st, 1959 and redeemable serially from September 1st, 1960 to September 1st, 1979 inclusively, at a rate of not less than 5% nor more than 6% per annum, payable semi-annually, on March 1st and September 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated July 13, 1959, modified\u2014extension to the central school.as For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from November 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $185.000.00 \u2014 20 years Year Capital September 1st, 1960.x 815,500.00 September 1st, 1961.x 16,500.00 September 1st, 1962.x 17,500.00 September 1st, 1963.x 18,500.00 September 1st, 1964.x 19,500.00 September 1st, 1965.4,500.00 September 1st, 1966.4,500.00 September 1st, 1967.5,000.00 September 1st, 1968.5.000.00 3752 G, iZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1969, Tome Ol, X° 88 1er septembre 1909.5,500.00 1er septembre 1970.5.500.00 1er septembre 1971.«.000.(M) 1er septembre 1972.6,500.00 1er septembre 1973.6,500.00 1er septembre 1974.7.000.00 1er septembre 1975.7.500.00 .1er septembre 1970.S.000.00 1er septembre 1977.8,500.00 1er septembre 1978.\"8,500.00 1er septembre 1979.9,000.00 Les \"x\" indiquent les minées durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 880,018.10.accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $16,009.62 chacun, de I960 à 1904 inclusivement, seront reçus et appliqués au service «le cet emprunt.1)¦ un corps politique et incorporé, ayant sa principale place d'affaires, pour la province de Québec, en les cité et district de Montréal, demandeur contre DELVIDA LE-GROS, du district de Beauharnois, résidant à Valleyfield, défendeur.A savoir: \"1° Le lot de terre désigné au cadastre officiel de la paroisse Ste-Cécilc, sous le numéro un, de la subdivision du lot numéro cent soixante-trois (163-1) mesurant cinquante pieds de largeur, sur cent vingt et un pieds de profondeur dans sa limite sud-ouest, et cent vingt-sept pieds dans sa limite nord-ouest.Fieri Facias de Bonis et de 'Terris District of Beauharnois Superior Court, ( TRADERS FIN AN CL No.4215.< 1 CORPORATION LTD.U body politic and corporai' having its principal place of business for the Province of Quebec, in the city and district of Montreal, plaintiff versus DELVIDA LEGROS of the district of Beauharnois, residing in Valley field, defendant.To wit: \"1.Lot of land designated on the official cadastre of the parish of Ste.Cécile, under number one, of the subdivision of lot numbei one hundred and sixty-three (163-1), measuring fifty feet in width by one hundred and twenty-one feet in depth within its southwesterly boundary, and one hundred and twenty-seven feet within its northwesterly boundary. QUEHEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec September 19th, 1969, Vol.91, No.8.S 3759 2° Le lot de terre désigné au susdit cadastr officiel sous le numéro deux de la subdivision du loi numéro cent soixante-trois, (163-2), mesurant cinquante pieds de largeur sur cent vingt et un pieds de profondeur dans Ui ligne nord-est, et cent dix-neuf pieds dans la ligne sud-ouest.Toutes les mesures ci-dessus sont plus ou moins et mesure anglaise.Avec toutes bâtisses y érigées, c t en particulier, la maison à deux logements se trouvant sur le lot N° 163-1.Pour être vendus au Bureau du Shérif, JEUDI, Je PREMIER jour d OCTOBRE 1959.à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, bureau du Shérif.ERNEST POIRIER.Salaberry de Vallevfield, ce 24ième d'août 1959.5133S-35-2-o [Première publication: le 29 août 1959] BEDFORD Canada \u2014 Province «le Québec District de Bedford < our Supérieure, i T> OU VILLE MASSE, cul-N° 8834.< *y tivateur, résidant et do-> micilié en la ville de St-\u2022 esaire, district de St-Hyacinthe, demandeur, s JOSEPH ROY, cultivateur, résidant et domicilié à Valcourt, district de Bedford, défendeur, et MONTY & LEFEBVRE, en leur qualité de régistrateurs pour la division d'enregistrement de Shefford, mis-en-cause.' \"Une ferme connue et désignée aux plan et \u2022ivre de renvoi officiels du cadastre du canton d'Ély, comté de Shefford, comme étant les lots numéros cinq cent trente-cinq, cinq cent trente-six et cinq cent trente-sept (Nos.535, 536, 537) i.vant respectivement en superficie: trente-trois acres et sept centièmes, trente-six acres et soixante-quinze centièmes et soixante-neuf acres et quatre-vingt-deux centièmes.Avec toutes les bâtisses dessus érigées.\" Pour être vendue en bloc, à la porte de l'église paroissiale de St-Joseph d'Ély de Valcourt, dans le comté de Shefford.district de Bedford, le JEUDI, premier jour d'OCTOBRE 1959, à DEUX heures de l'après-midi.Le Député Shérif, Bureau du Shérif, ANTOINE BOURASSA.Sweet.shurg, Que., Ce 24 août 1959.51337-35-2-u CHICOUTIMI Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec District «le Chicoutimi Cour Supérieure, ( \"CR EDDY J E A N.mar-N° 11,872.< chaud, de Ste-Anne.dis-v trict de Chicoutimi, P.Q., demandeur; vs LUDGER SASSEVILLE, autrefois des cité et district de Chicoutimi, maintenant de St-Léon de Labrecque, P.Q., défendeur.Contre le défendeur: La demi-sud des lots 16 et 17, dans le rang 4, au cadastre officiel du canton Labrecque, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus \"en bloc\", à la porte de l'église paroissiale de St-Léon de Labrecque, le 2° Lot of land designated on the abovemen-tioned official cadastre under number two of the subdivision of lot number one hundred and sixty-three (163-2), measuring fifty feet in width by one hundred ami twenty-one feet in depth within its northeasterly line, and one hundred ami nineteen feet within its southwesterly line.All the above measurements arc more or less and in English measure.With all the buildings thereon erected, and more particularly, the two-tenement house located on lot No.163-1.To he sold at the Sheriff's Office, THURSDAY the FIRST day of OCTOBER.1959.at TEN o'clock in the forenoon.ERNEST POIRIER, Sheriff's Office, Sheriff.Salaberry de Valleyfield, this August 24th, 1959.51338-35-2 [First publication: August 29.1959] BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court./ \"D OUVILLE MASSE, far-No.8834.\\ mer, residing and do-^ m ici led in the town of St-Césaire, district of St-Hyacinthe, plaintiff, vs JOSEPH ROY, farmer, residing and domiciled at Valcourt, «listrict of Bedford, plaintiff, and MONTY & LEFEBVRE, in their quality of registrars for the registration division of Shefford, mis-en-cause.\"A farm known and designated on the official plan and in the book of reference of the cadaster of the township of Ely, county of Shefford, as being lots numbers five hundred and thirty-five, five hundred ami thirty-six and five hundred and thirty-seven (Nos.535, 536, 537) having respectfully and area of: thirty-three acres and seven / one hundreths, thirty-six acres and seventy-five / one hundredths and sixty-nine acres and eighty-two / one hundredths.With all the buildings thereon erected.\" To be sold in block at the parochial church door of St-Joseph d'Ély de Valcourt, in the county of Shefford, district of Bedford, on THURSDAY, the FIRST day of OCTOBER.1959.at TWO o'clock in the afternoon.ANTOINE BOURASSA, Sheriff's Office, Deputy Sheriff.' Sweetsburg, Que.August 24.1959.51337-35-2 CHICOUTIMI Fieri Facias ( 'anada \u2014 Province of Quebec District of Chicoutimi Superior Court.( \"DR E D I) Y J E A N, mer-No.11,872.\\ L chant, of Ste.Anne, dis-^ trict of Chicoutimi, P.Q., plaintiff, vs LUDGER SASSEVILLE.formerly of the city and district of Chicoutimi, presently of St.Léon de Labrecque, P.Q., defendant.Against the defendant: The southerly half of lots 16 and 17, in range 4, of the official cadastre of the township of Labrecque, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold \"en bloc\", at the door of the parochial church of St.Léon de Labrecque, the 3700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 19Ô9, Tome 91, N° 88 VINGT-DEUXIÈME jour du mois d'OCTOBRE 1959.à TROIS heures de L'après-midi.Bureàil du Shérif, Ia> Shérif.Chicoutimi.RENÉ DELISLE.le 14 septembre 1959.51499-38-2-0 -Sç- GASPË Fieri Facias de Terris District de Rimouski Cour de Magistrat.( T ES COMMISSAIRES N° 37.142.38.909.< D'ÉCOLES DE CAP-l AU-RENARD, corps politique incorporé ayant un bureau d'affaires dans la municipalité de Cap-au-Renard, demandeur, vs ACHILLE VALLÉE.Cap-au-Renard, comté de Gaspé, défendeur.La propriété â vendre est la suivante: \"Une terre étant partie du lot N° 22-B, 1er rang, canton Christie, bornée au nord au fleuve St-I/Jiurcnt, à l'est par le N'° 23-A, au sud au 2ième rang à l'ouest à Octave Vallée, contenant en superficie 09 acres, avec bâtisses dessus construites.A distraire un emplacement donné â Valmont Vallée, faisant partie dudit lot 22-B\".Avis est par le présent donné (pie la venté des immeubles saisis dans la présente cause, qui devait avoir lieu à la Rivière à Martre, le 4 août 1959, à 2.00 heures de l'après-midi, aura lieu â la porte de l'église de Ste-Anne-des-Monts, MARDI, le VINGTIÈME jour d'OCTOBRE 1959, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif.Ruïeau du Shérif, .1.E.MEAGHER.Percé, le 15 septembre 1959.51509-o Fieri Facias de Bonis Cour Supérieure.(TVVME VEUVE ODILON Rimouski.) SERVANT, marchande N° 20.255.\\ publique de l'endroit appelé ' St-Joachim de Tourelle, district de (Jaspé.P.Q., demanderesse, vs GERMAIN VALLÉE de l'endroit appelé St-Joachim de Tourelle, Gas|>é Nord, P.Q., défendeur.La propriété à vendre est la suivante: \"Une maison d'habitation appartenant au débiteur Germain Vallée sise sur un certain terrain, propriété de Dame Alphonsine Therrien, vve de feu Emile Vallée, ledit terrain faisant partie des lots 10-B et 10-C du cadastre officiel pour le premier rang du canton Tourelle, et mesurant (piatre cent vingt pieds (420') de largeur par cinq cent vingt pieds (520') de profondeur moyenne, le tout [dus ou moins, borné vers le nord-ouest par le Boulevard Perron, vers le nord-est par le lot 16-D de Lionel Vallée, vers le sud-est par le résidu des lots 10-B et 10-C de Lionel Vallée et vers le sud-ouest par le lot 10-A appartenant |>our partie à Charles Labire et pour partie à Edmond Brisebois.\" Pour être vendu à la porte de St-Joachim de Tourelle, MARDI le VINGT-QUATRIÈME jour d'OCTOBRE 1959 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.E.MEAGHER.Percé 14 septembre 1959.51510-38-2-o Fieri Facias de Bonis Cour de Magistrat,.C YNDICS DE LA PA-Gaspé, ) O ROISSE DE ST-MAR-N° 13102.\\ TIN DE RIVIÈRE AU (RENARD, comté de Gas- TWE NT Y-SECOND day of the month of OCTOBER.1959.at THREE o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, RENÉ DELISLE, Chicoutimi, Sheriff September 14, 1959.51499-38-2 GASP É Fieri Fanas de Terns District of Rimouski Magistrate's ( ouït, i '-THK SCHOOL (0\\I.No.37.142.38.909.¦< 1 MISSIONERS OF I CAP-AU-RENARD, body politic and corporate having its business office in the municipality of Cap-au-Renard, plaintiff vs ACHILLE VALLÉE, Cap-au-Renard.county of Gaspé, defendant.The property to be sold is the following: \"A farm being part of lot No.22-B.range one, township Christie, bounded northerly by the St.Lawrence River, easterly by No.23-A, southerly by range two, westerly by Octave Vallée, containing an area of 09 acres, with buildings thereon erected.Save and except an emplacement given to Valmont Vallée, forming part of said lot 22-B\".Notice is hereby given that the sale of the immoveables seized in this cause, which was to have been held at Rivière à Martre, August 4.1959, at 2.00 o'clock in the afternoon, shall be held at the door of the Church of Ste.Anne-des-Mdnts, TUESDAY, the TWENTIETH dav of OCT'' BER 1959, at TWO o'clock in the afternoon.J.F.MEAGHER, Sheriffs Office.Sheriff.September 15, 1959.51509-1 Fieri Facias de Bonis Superior Court, ( \"TyVME ODILON SER-Rimouski, ; ' VANT, widow, publi No.20,255.\\ merchant of the place called ' St.Joachim de Tourelle, district of Gaspé P.Q., plaintiff, vs GERMAIN VALLÉE of the place called St.Joachim de Tourelle.Gaspé North.P.Q., defendant.The property to be sold is the following: \"A dwelling-house belonging to the debtor Germain Vallée stiuate on a certain piece of land, property of Dame Alphonsine Therrien.widow of the late Emile Vallée, the said land forming part of lots 10-B and 10-C of the official cadastre for range one of the township of Ton relic, and measuring four hundred and twentj feet (420') in width by five hundred and twentj f(et (520') of average depth, all of which more or less, bounded northwesterly by the Perron Boulevard, northeasterly by lot 16-1) of Lionel Vallée, southeasterly by the residue of lots 10-B and 10-C of Lionel Vallée, southwesterly by lot 16-A belonging partly to Charles Labire and partly to Edmond Brisebois.\" To be sold at the door of the Church of St.Joachim de Tourelle, TUESDAY the TWENTY-FOURTH day of OCTOBER 1959.at TEN o'clock in the afternoon.J.F.MEAGHER.Sheriff's Office, Sheriff.Percé, September 14.1959.51510-38-2 Fieri Facias de Bonis Magistrate's Court, / THE TRUSTEES OF Gaspé, j A THE PARISH OF No.13102.)ST.MARTIN DE RI-{VI ÈRE AU RENARD, QUEliEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1969, Vol.91, No.88 376J l\u201e.P.Q., demandeur, vs FERNAND RIOUX, Rivière au Renard, comté de (Jaspé.P.Q., d fondeur.La propriété à vendre est la suivante: \"Lot N° 77-0 du rang sud de la rivière, canton Fox, borné au nord par le Boulevard Perron, au nord-est par le lot 77-8 propriété de la Fabrique de Rivière au Renard, au sud-est par le lot 77-7 chemin propriété de Elzéar Boulay et Albert Morris et par le lot 77-8.propriété de la Fabrique de Rivière au Renard, et au sud-ouest par le lot 102-1 propriété de Uldège Dufresne, par le lot 102-2, un chemin privé et par le lot 103-1, un chemin privé contenant une superficie totale de 18S00 pieds carrés.\" Pour être vendu à la porte de l'église de Rivière au Renard.MARDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'OCTOBRE 1959, à DIX heures de l'avant-midi.Ix« Shérif, Bureau du Shérif.,L F.MEAGHER.Percé, 14 septembre 1059.51511-38-2-0 HULL Canada - Province de Québec-District de Hull Cour Supérieure, ( TNTERPROVINCIAL N°6539.-J A BUILDING CRE-'DITS LTD.un corps politique et corporatif, ayant son siège social en la cité de Toronto, en la province d'Ontario et une place d'affaires en les cité et «listrict de Montréal, demanderesse; vs MARCEL LEGARE, «lu canton de Hull sud, dans le district de Hull, défendeur.\"La subdivision numéro «piatre cent vingt-neuf «lu lot numéro cinq «lu cinquième rang (R.V Ô-429) aux plan et livre de renvoi officiels «lu canton de Hull.Ensemble avec les const mêlions «Icssus érigées et les améliorations qui y furent exécutées et tous droits, membres et dépendances y appartenant.\" Pour être vendue à mon bureau, au Palais de Justice; en la cité «le Hull, le VINGT-TROISIEME jour d'OCTOBRE prochain, à TROIS heures «le l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-ITERRE.Hull, le 1er septembre 1959.51491-38-2 Canada \u2014 Province de Québec District de Hull ( Jour Supérieure ( TN T E R P ROVINCI A L N° 2734.< 1 BUILDING CREDITS ' LTD., un corps politique et corporatif, ayant son siège social et principale place d'affaires en la cité «le Toronto, dans la province d'Ontario, et une place «l'affairés en les cité et «listrict «le Montréal, demaiulcresse.vs EDGAR CONSTANTINEAU, des cité et «listrict «le Hull, défendeur.\"La subdivision 99 «lu lot numéro 5 du cinquième rang aux plan et livre de renvoi officiels «lu canton «le Hull.Ensemble avec toutes les constructions «lessus érigées et les améliorations «pii y furent exécutées et tous droits membres et dépendances y appartenant.\" Pour être vendue à mon bureau, au Palais de Justice, en la cité de Hull, le VINGT-TROISIÈME jour d'OCTOBRE prochain, à DEUX heures «le l'apr«\\s-mi«li.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, R.ST-PIERRE.Hull, le 1er septembre 1959.51493-38-2 county of Gaspé, P.Q., plaintiff, vs FERNAND RIOUX.Rivière au Renard, countv of (Jaspé.P.Q., defendant.The property to be sold is the following: \"Lot No.77-0 «>f range south of the river, township of Fox, bounded northerly by the Perron Boulevard, northeasterly by lot 77-8, the property of the Fabrique of Rivière au Renard, southeasterly by lot 77-7 road, property of El/éar Boulay and Albeit Morris and by lot 77-8, property of the Fabrique of Rivière au Renard, and southwesterly by lot 102-1.property of Uldège Dufresne.by lot 102-2, a private road and by lot 103-1.a private road containing a total area f business in the city and «listrict of Montreal, plaintiff; vs MARCEL LÉGARÉ, of the township of South Hull, in the «listrict of Hull, defendant.\"Subdivision number four hundred ami twenty-nine of lot number five in the fifth range (R.V 5-429) on the official plan and in the book of reference for the township of Hull.Together with all buildings thereon erected and improvements thereon made ami all rights, members ami appurtenances thereunto belonging\".To be sold at my office, at the Court House in the city of Hull, the TWENTY-THIRD day of OCTOBER next, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST-PIERRE, Sheriff's Office.Sheriff.Hull.September 1st.1959.5149l-38-2-o Canada Province of Queln-c District of Hull Superior Court, ( TN T E R P RO V I N CIAL No.2734.j a BUILDING CREDITS \\LTD., a body politic and corporate having its head office and principal place of business in the city of Toronto, in the Province «>f Ontario, and a place of business in the city and «listrict of Montreal, plaintiff, vs EDGAR CONSTANTINEAU.of the city and district of Hull, defendant.\"Subdivision 99 of lot 5 in the fifth range on the official plan ami in the book of reference for the township of Hull.Together with all buildings thereon erecte«l and improvements thereon made and all rights, members and appurtenances thereunto belonging.\" To be sold at my office, at the Court House, in the city of Hull, the TWENTY-THIRD day «)f OCTOBER next, at TWO o'clock in the afternoon.R.ST-PIERRE.Sheriff's Office.Sheriff.Hull.September 1st.1959.51493-38-2-o 3762 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° SS JOLI ETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Cour Supérieure, t \"D OSAIRE VACHON, des N° 95,786.\"j ^ cité et district de Qué-n bec y faisant affaire seul, sous les nom et raison sociale de \"Admirai Stainless Steel Reg'd\", demandeur, vs CLAIRE FERLANT), épouse de Lucien Aicouette, tous deux de lieux inconnus faisant ci-devant affaires seule tant à Trois-Rivières, Québec et Montréal sous les nom et raison sociale de \"Claire Ferland Fina Ware Enrg.\" comme marchande publique avec le consentement de son mari et ce dernier mis en cause pour autoriser et assister saditc épouse aux fins des présentes, défendeurs.Comme appartenant aux défendeurs: \"Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent trentc-A-doùze (P-530-A-12) du cadastre officiel du village de St-Gabriel de Brandon de la contenance de tout le terrain compris entre le terrain d'Albertin Desrochers (n° 530-B-l), le terrain de Gabriel Lemire (n° 530-B-2), le terrain de la Fabrique de St-Gabriel de Brandon d'un côté (n° 530-M-l).le terrain d'Adélard Houle (n° 529) en arrière et autre partie dudit lot 530-A-12 appartenant à Hildège Desrochers de l'autre côté et borné en front par la rue St-Gabriel, et toutes les constructions dessus élevées (Hôtel et restaurant), circonstances et dépendances, sujet aux servitudes existantes.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Gabriel de Brandon, JEUDI, le PREMIER jour d'OCTOBRE 1959, à ONZE heures de l'avant-midi.Ix> Shérif.Bureau du Shérif, ROLAND PERRAULT.Joliette, 24 août 1959.51341-35-2-o JOLIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Qucl>ee District of Quebec Superior Court.( J3 OSAIRE VACHON 0f No.95,786.\\ -tv the city and districl of ' Quebec, carrying on business therein alone, under the name and style of \"Admiral Stainless Steel Reg'd\", plaintiff vs CLAIRE FERLAND, wife of Lucien Arcouette, both of unknown whereabouts, formerly carrying on business alone in Trois-Rivières as well as in Quebec ami Montreal, under the name and style of \"Claire Ferland Fina Ware Enr.'\\ as public merchant with the consent of her husband ami the latter mis-on-eause in order to authorize and assist his said wife for the purposes herein, defendants.As belonging to the defendants: \"A piece of land known and designated as being a part of lot five hundred and thirl v \\-twelve (P-530-A-12) of the official cadastre of thé village of St.Gabriel de Brandon containing all the land included between the land of Albcrtin Desrochers (No.530-B-l).the land of Gab iel Lemire (No.530-B-2), the land of the Fabrique of St.Gabriel de Brandon on one side (No.5! I-M-l).the land of Adélard Houle (No.529.n the rear and another part of said lot 530-A-12 belonging to Hildège Desrochers on the other side and bounded in front .by St.Gabriel \"Street, and all the structures erected thereon (Hotel and restaurant), circumstances and dependen oies, subject to the existing servitudes.To be sold at the door of the parochial church of St.Gabriel de Brandon, THURSDAY II FIRST day of OCTOBER 1959, at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERRAULT.Sheriff's Office.Sheriff Joliette.August 24, 1959.51341-35 I KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Kamouraska Cour Supérieure, ( T3 AYMOND LANGEAIS.N° 21,188.\\ f\\ garagiste, faisant affaires v à Rivière-du-Loup, sous la raison sociale de \"Langlais & Bérubé Auto.Enr'g\".vs PHILIAS BOUCHER, cultivateur, résidant à St-François-Xnvier de Niger, défendeur.1.Une maison situé sur le lot numéro dix-sept (17) rang cinq, Canton Hocquart, avec un terrain de cinquante pieds de front sur soixante pieds de profondeur, tel que le tout est réservé dans la vente par Réal Dumais à Joseph Paré, passée le 24 août 1954, et enregistrée au bureau d'enregistrement de la divison de Témiscouata, sous le numéro cent vingt-trois huit cent quatre-vingt-deux (123,882).2° Une terre contenant environ deux cents acres en superficie, connue sous les numéros dix-sept et dix-huit, (17-1.S) rang cinq, canton Hocquart, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, sauf à distraire le terrain de l'école, le terrain de Hermel Rousseau, et le terrain de Réal Dumai, avec les bâtisses dessus construites sur ce terrain privé.Le tout pour être vendu à la porte de l'église de St-Cyprien.le VINGT-SIXIÈME jour KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Qucl)ee District of Kamouraska Superior Court, ( t> AYMOND LANGLAIS, No.21,188.\\ garage-keeper, carrying Mm business at Rivière-di Loup, under the name and stvle of \"Langlais & Bérubé Auto, Enr'g\".vs ITIILIAS BOUCHER, farmer, risiding at St.François-Xavier de Viger, defendant.1.A house situate on lot number seventeen (17) range five, township of Hocquart, with n piece of land of fifty feet of frontage by sixty feel of depth, all of which as reserved in the sale bj Real Dumais to Joseph Paré, passed August 24, 1954, and registered at the registry office of tin division of Témiscouata, under number one hundred and twenty-three eight hundred and eighty-two (123,882).2.A farm containing some two hundred acres in area, known under number seventeen and eighteen, (17-18) range five, township of Hocquart, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, save and except the land of the school and the land of Hermel Rousseau, and the land of Real Dumais, with the buildings thereon erected on this private land.All of which to be sold at the door of the church of St.Cyprien.the TWENTY-SIXTH day of QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.38 3763 d'OCTOBRE 1959 (vingt-sixième jour d'octobre !959).à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif du Bureau du Shérif, district de Kimouraska, Rivière-du-Ixmp.CYRILLE PELLETIER, ce 12ème jour nord 38) du canton de Salaherry.Pour être vendu en bloc à la porte de l'église catholique de St-Jovite, comté de Terrebonne, MERCREDI, le TRENTIÈME jour dé SEPTEMBRE 1959 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, GEO.AUCLAIR.St-Jérôme.19 août 1959.51318-35-2-o hundred and twenty acres, more or less, with house and dependencies thereon erected, less and to withdraw from this lot the school emplacement originally sold by registered deed under number 44746 and today belonging t0 William McMahon by registered deed number 6386.2.The northern half of lot thirty-eight [}/2 North 38) of the township of Salaberry.To be sold in block at the Catholic church door of St-Jovite, county of Terrebonne, WEDNESDAY, the THIRTIETH day of SEPTEMBER, 1959, at TWO o'clock in the afternoon.GEO.AUCLAIR, Sheriff's Office, Sheriff.St-Jérôme, August 19, 1959.51318-35-2 < lanada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure.( THOMAS CHAR BON-NT0 29185.S 1 XEAU.camionneur de l la municipalité de Piedmont, comté et district de Terrebonne, demandeur vs RÉAL TROTTIER de la paroisse dé St-Sauveur des Monts, comté et district «le Terrebonne, et JEAN PAUL ALARY du village St-Sauveur, comté et district de Terrebonne, défendeurs.AVIS DE VENTE Les édifices situés sur un certain immeuble situé à Saint-Sauveur des Monts, comté de Terrebonne, pris à même le lot de terre, désigné sous le numéro 250 au cadastre officiel de la paroisse de St-Sauveur; L'immeuble présent vendu mesure 100 pieds de largeur sur 100 pieds de profondeur, mesures anglaises.L'immeuble présentement vendu est borné sur les quatre côtés ou d'autres parties du même lot 250 restant la propriété de la présente venderesse; L'immeuble présentement vendu est remplacement où est situé la maison construite par le présent acquéreur.Pour être vendu à la porte de l'église catholique de St-Sauveur des Monts, comté de Terrebonne.JEUDI, le VINGT-DEUXIÈME jour d'OCTOBRE 1959 à DEUX heures TRENTE de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.GEORGES AUCLAIR.St-Jérôme.10 septembre: 1959.51495-38-2-0 Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, I THOMAS CHARBON-No.29185.\\ NEAU, trucker of the I municipality of Piedmont, county and district of Terrebonne, plaintiff; vs REAL TROTTIER, of the parish of St.Sauveur des Monts, county and district of Terrebonne, and JEAN PAUL ALARY, of the village of St.Sauveur, county and district of Terrebonne, defendants.NOTICE OF SALE The buildings situate on a certain immoveable situated at Saint Sauveur des Monts, county of Terrebonne, taken from lot of land designated under number 250 of the official cadastre of the parish of St.Sauveur; The immoveable presently sold measures 101» feet in width by 100 feet in depth, English measure.The immoveable presently sold is bounded on four sides or other parts of the same lot 250 remaining the property of the present vendor; The immoveable presently sold is the emplae< ment where the house, erected by the purchaser, is situated.To be sold at the door of the Catholic church of St.Sauveur des Monts, county of Terrebonne THURSDAY the TWENTY-SECOND day of OCTOBER 1959 at TWO-THIRTY o'clock in the afternoon.GEORGES AUCLAIR, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, September 10, 1959.51495-38-1' TROIS-RIVIÈRES Canada \u2014 Province de Québec District de Trois-Rivières (our Supérieure.( T A BANQUE PROYTN-N° 20870.^ ^ CIA LE DU CANADA.> corps politique et incorporé, ayant son siège social et sa principale place d'affaires dans les cité et district de Montréal, demanderesse, vs ROGER LA PERRIÈRE, de la ville de Shawinigan-Sud, district des Trois-Rivières, défendeur.\"Un lot de terre situé à Shawinigan-Sud 2.sur la cent dix-neuvième rue, connu et désigné comme étant le lot numéro cent trente-six, de la subdivision du lot originaire numéro neuf cent dix-neuf (919-136) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Notre-Dame du Mont-Carmel.Mesurant cinquantç-cinq pieds et cinq dixièmes de pied (55.5') de TROIS-RIVIÈRES Canada \u2014 Province of Quebec District of Trois-Rivières Superior Court, ( THE PROVINCIAL No.20870.< 1 BANK OF CANADA.I body politic and corporate, having its head office and principal place of business in the city and district of Montreal, plaintiff vs ROGER LA PERRIÈRE, of the town of Shawinigan-South, district of Trois-Rivières, defendant.\"A lot of land situated in Shawinigan-South 2.on one hundred and nineteenth Street, known and designated as being lot number one hundred and thirty-six, of the subdivision of original lot number nine hundred and nineteen (919-136) of the official plan and book of reference of the cadastre of the parish of Notre-Dame du Mont-Carmel.Measuring fifty-five feet and five tenths of a foot QUEBEC.OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959, Vol.91, No.38 3767 largeur sur la profondeur de quatre-vingt-cinq pieds (85').Mesure anglaise.Avec circonstances et dépendances et toutes les bâtisses dessus construites.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Shawinigan-Sud, VENDREDI, le DEUXIÈME jour du mois d'OCTOBRE, mil neuf cent cinquante-neuf, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, L.P.MERCIER.Trois-Rivières, ce 25 août 1959.51355-35-2-0 (55.5') in width by a depth of eighty-five feet (85').English measure.With circumstances ami dependencies and all the buildings thereon erected.\" To be sold at the door of the parochial church of Shawinigan-South.FRIDAY the SECOND day of the month of OCTOBER, one thousand nine hundred and fifty-nine, at THREE o'clock in the afternoon.L.I'.MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.Trois-Rivières.this August 25.1959.51355-35-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N° 38 Action en séparation de biens: IInon vs Tavan.3719 Yuhktk en Conseil: 74X-C Alimentation au détail, région de Québec (Erratum).3719 Avis aux intéressés: 3689 Avis divers: Artists and Photographers Inc.(Directeurs) .3724 Charles E.Erosst & Co.(Directeurs).3723 Central Truck Lines Ltd (Directeurs).3720 Clinique Métropolitaine Dici\u2014 Métropolitain Clinic Inc.(Directeurs).3723 Consolidated llalliwell Limited (Directeurs).3721 David & Frères.Limitée (Directeurs).3720 Ed.Archambault Inc.3722 Foundation Steel Specialities Inc.(Directeurs).3721 Oagnon Frères \"Exécutif\" Ltée (Directeurs).3724 La Corporation des Administrateurs Professionnels \u2014 The Corporation of Professional Administrators (Règlements) .3723 La Laiterie Pcrf onde val Limitée (Directeurs).- .3722 La Sarre Power Company, Limited.(Barrage).3720 Lemoyne Oil Co.Ltd \u2014 I^a Cie d'Huile Lcmoyen Ltée (Directeurs).3724 Marché Union Inc.(Directeurs).3721 Masse.Paul (Vente).3725 Noé Bourassa.Limitée (Directeurs).3720 Quick Flame Gas Ltd (Directeurs).3722 Sheraton Hotels Limited (Directeurs).3725 Shorccrest Development Inc.(Directeurs) .3724 Syndicat Immobilier de Maria (Fondation) .3724 Bills, Assemblée législative: Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session 3726 Chartes \u2014 A b a n don n e : Almomi Limited.3727 Chaussure Laçasse Limitée.3727 International Fabrics lue.372(5 Index of the Quebec Official Gazette, No.38 Action for Separation as to Property: Huon vs Tavan.3719 Order in Council: 748-C-\u2014Food Products Retail Trade.region of Quebec (Eiratum).3719 Notice to Interested Parties: 3089 Miscellaneous Notices: Artists and Photographers Inc.(Directors) .3724 Charles E.Frosst & Co.(Directors).3723 Central Truck Lines Ltd (Directors)., 3720 Metropolitan Clinic Inc.\u2014 Clinique Métropolitaine Inc.(Directors).3723 Consolidated llalliwell Limited (Directors) .3721 David & Frères.Limitée (Directors).3720 Ed.Archambault Inc.(Directors).3722 Foundation Steel Specialities Inc.(Directors).3721 Gagnon Frères \"Exécutif\" Ltée (Directors).3724 The Corporation of Professional Administrators \u2014 La Corporation des Administrateurs Professionnels (By-Laws).3723 \\m Laiterie Porfondeval Limitée (Directors).3722 La Sarre Power Company, Limited.(Dam).3720 Lemoyne Oil Co.Ltd - La Cie d'Huile Lemoyne Ltée (Directors).3724 Marché Union Inc.(Directors).3721 Masse.Paul (Sale).3725 Nfoé Bourassa.Limitée (Directors).3720 Quick Flame Gas Ltd (Directors).3722 Sheraton Hotels Limited (Directors).3725 Shorccrest Development Inc.(Directors).3724 Syndicat Immobilier de Maria (Foundation).3724 Bills, Legislative Assembly: Concerning private bills which shall be introduced during the coining session.3726 Charters- -Surrender ok: Almomi Limited.3727 Chaussure Laçasse Limitée.3727 International Fabrics lue.3726 3768 GAZETTE OFFICIELLE DE 01 'ÉBFA\\ Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° SS Lido Development Corporation.3726 Mitchell Holdings (1937) Limited.3727 Vinyl Lines (Canada) Ltd.3726 Compagnie autorisée à paire des affaires: Atlantic Airline and Electronic Schools Ltd.3727 ( lOMPAGNIES DISSOUTES: Belle Fleur Construction Corp.3727 Edifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.3728 I*a Compagnie d'Aqueduc du Village de Lot lanière.3728 Quebec Coal & Oil Limited.372S D km a.sdks à LA législature! Commissaires d'écoles pour la munie.de Les Méchins.3730 Congregation Shomrim Laboker-Bcth Yehudah and Affiliated Congregation Shaare Tefillah.3729 Gaz National Inc.\u2014 National Gas Inc.3730 La Mutuelle des Commissions Scolaires, Compagnie d'Assurances Générales.3730 The Steel Company of Canada Limited 3729 DÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Graceficld.3731 Les Saules.3731 St-Jean-Baptiste de Montréa-Sud.3731 Terres et Forêts: Service du Cadastre: Aulneau.canton.3732 Begin, canton.3732 Dalmas, canton.3732 Gamier, canton.3732 Labrecque, canton.3733 Letellier, canton.3731 Notre-Dame de la Victoire, paroisse.3732 Rouleau, canton.3733 Taillon, canton.3733 Travail: Industrie ou métiers de: Construction, région des Cantons de l'Est (Modification).3736 ( instruction, région de Montréal (Avis) 3733 Imprimerie, région de Montréal (Modification) .3736 Métal en feuilles.Ile de Montréal et un rayon de lô milles (Modification).3738 Examens du Barreau: Laurentidcs, étude.3741 Saguenay, étude.3741 St-François, étude.3741 Lettres patentes: Alamac Realtv Corp.3690 Alfred Holding Corp.3691 Atomic Paint Works Inc.3091 Lido Development Corporation.3726 Mitchell Holdings (1937) Limited :;7l>7 Vinyl Lines (Canada) Ltd.3726 Company Licensed to do Business: Atlantic Airline and Electronic Schools Ltd.3727 Companies Dissolved: Belle Fleur Construction Corp.'¦'>'.27 Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.372S I^a Compagnie d'Aqueduc du Village de Lotbinière.3728 Quebec Coal-Oil Limited.3728 Applications to Legislature: School commissioners for the municipality of Les Méchins.3730 Congregation Shomrim Lahokcr-Bcth Yehudah and Affiliated Congregation Shaare Tefillah.372 I National Gas Inc.\u2014 Gaz National Inc.3730 The School Commissions Mutual.General Insurance Company.3731) The Steel Company of Canada Limited 3729 I ) E PA RTM E NTAI, NOTK ES : Education : School Municipality of: (i race field.3731 Les Saules.373! St-Jean-Baptiste de Montréal-Sud.3731 Lands and Forest: Cadastral Branch: Aulneau.township.7332 Begin, township.3732 Dalmas.township.3732 Gamier, township.3732 I^ibrccquc.township.3733 Letellier, township.3731 Notre-Dame de la Victoire, parish.3732 Rouleau, township.3733 Taillon.township.3733 Labour : Industry or 'Trades of: Construction, Eastern townships district (Amendment).¦ 3730 Construction, region of Montreal (Notice) 3733 Printing, region of Montreal (Amendment) .3730 Sheet Metal.Island of Montreal and a radius of lô miles (Amendment).373N Bah Examinations: Laurentidcs.study.3741 Saguenay, study.3741 St.Francis, study.3741 Letters Patent: Alamac Realtv Corp.3690 Alfred Holding Corp.3691 Atomic Paint Works Inc.3691 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th, 1959.Vol.91, No.88 3769 Attractions Touristiques Lauren tiennes Inc.3(591 Austria Bajery Limited.3092 Bellérive Bowling Inc.3692 Benmar Hosiery Mills Ltd.3692 Bol) Lunny Sporting ( Joods Ltd.3693 Boutin Transport Ltée.3693 Brompton Construction Inc.3(593 Canabo Inc.3694 Canadian Tire & Repair (La Tuque) Co.Ltd.3694 Canora Development Corp.3694 Centre des Jeunesses Musicales du Canada à Montréal.3695 Chong Wah Noodle Manufacturing Company Inc.3695 ( 'lui) Nautique du Lac Cimon.3095 Coaticook Finance Inc.3(59(5 Corporation Bienvenu.3090 Delnor Development Inc.3(590 Deviro Development Ltd.3(597 Drummond Seat ('over Center Ltd.3097 Duvalco Realty Co.Ltd.3097 Édifice Charette Limitée.3698 Fabrique Nationale de Monte-Fentes et Téléphériques Inc.3698 Foothill Investments Ltd.3098 General Automatic; Laundry Co.Inc\u2014 3099 Grant's Concrete Products Incorporated \u2014 Les Produits de Béton Grant Incorporé.3099 Guy Inc.3700 Hanover Development Corp.3700 Harwick Development Corporation.3700 Hollywood Hosiery Mills Ltd.3701 Hôpital Jean-Marie Vianney Inc.3701 Irmur Investments Inc.3701 Island Enterprises Inc.3702 J.A.St-Jacques Limitée \u2014 J.A.St- Jacques Limited.3702 J.I.Cadieux.Inc.3702 Jo-Mar Investment Corp.3703 Jurie Ltd.3703 Kildare Development Corp.3703 Kingbury Asbestos Mines Limited.3704 Kotnor înc.3704 Lamlsdownc Storage Ltd.3704 \\a\\ Société L:; Page lue.3705 Le Club de Course Sous Harnais de Clermont Inc.3705 Les Immeubles C.J.L.R.Inc.370(5 Les Immeubles Lachapelle Ltée.370(5 Les Jardins Napierville Inc.3700 Les Loisirs de la Paroisse Saint-Jean- Baptiste de Sherbrooke.3707 Loranger Électrique lue.3707 Mimosa Investments Corp.3707 Morin Mining Exploration Ltd.3707 Mutual Land Corporation.3708 Nadmar Corp.370S O.R.Products (Canada) Ltd.3709 Paul Robert.Limitée.3709 Peldue Investment Corp.3709 Pelnar Construction Inc.3710 Pension du Nord Limitée.3710 Philippe Gignac Inc.3710 Pvromors of Canada Ltd.3711 Roléon lue.3711 Roll-Y-Rush Home Maintenance Inc.3711 Ste-Geneviève Construction Inc.3712 St.George Motor Hotel Inc.3712 St.Jérôme County Realty (Que) Inc.3712 St.Philippe Realty Corp.3713 St.Raphaël Enterprises Corp.3713 St.Raphaël Investment Corp.3713 St.Raphaël Realty Corp.3714 Sept-Iles Masonry Ltd.\u2014 Maçonnerie Sept-Iles Ltée.3714 Attractions Touristiques Laurentiennes Inc.3691 Austria Bajery Limited.3692 Bellérive Bowling Inc.3692 Benmar Hosiery Mills Ltd.3692 Bob Lunny Sporting (Joods Ltd.3693 Boutin Transport Ltée.3693 Brompton Construction Inc.3693 Canabo Inc.3694 Canadian Tire & Repair (La Tuque) Co.Ltd.3694 Canora Development Corp.3(594 Centre des Jeunesses Musicales du Canada à Montréal.3695 Chong Wah Noodle Manufacturing Company Inc.3695 Club Nautique du Lac Cimon.3695 Coaticook Finance Inc.3696 Corporation Bienvenu.3696 Delnor Development Inc.3696 Deviro Development Ltd.3697 Drummond Seat Cover Center Ltd.3697 Duvalco Realty Co.Ltd.3697 Édifice Charette Limitée.3698 Fabrique Nationale de Monte-Pentes et Téléphériques Inc.3C98 Foothill Investments Ltd.3698 General Automatic I/uindry Co.Inc.3699 Grant's Concrete Products Incorporated \u2014 Les Produits de Béton (îrant Incorporé.s.3699 Guy Inc.3700 Hanover Development Corp.3700 Harwick Development Corporation.3700 Hollywood Hosiery Mills Ltd.3701 Hôpital Jean-Marie Vianney Inc.3701 Irmur Investments Inc.3701 Island Enterprises Inc.3702 J.A.St-Jacques Limited \u2014 J.A.St-Jacques Limitée.3702 J.I.Cadieux.Inc.3702 Jo-Mar Investment Corp.3703 Jurie Ltd.3703 Kildare Development Corp.3703 Kingbury Asbestos Mines Limited.3704 Kotnor Inc.3704 Landsdownc Storage Ltd.3704 La Société Ix> Page Inc.3705 Le Club de Course Sous Harnais de Clermont Inc.3705 Les Immeubles C.J.L.R.Inc.3700 Les Immeubles Lachapelle Ltée.3700 Les Jardins Napierville Inc.3706 Les Loisirs «le la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke.3707 Loranger Électrique Inc.3707 Mimosa Investments Corp.3707 Morin Mining Exploration Ltd.3707 Mutual Land Corporation.3708 Nadmar Corp.3708 O.R.Products (Canada) Ltd.3709 Paul Robert.Limitée.3709 Peldue Investment Corp.3709 Pelnar Construction Inc.3710 Pension du Nord Limitée.3710 Philippe Gignac Inc.3710 Pyromors o?Canada Ltd.3711 Roléon Inc.3711 Roll-Y-Rush Home Maintenance Inc.3711 Ste-Geneviève Construction Inc.3712 St.George Motor Hotel Inc.3712 St.Jérôme County Realty (Que) Inc.3712 St.Philippe Realty Corp.3713 St.Raphaël Enterprises Corp.3713 St.Raphaël Investment Corp.3713 St.Raphaël Realty Corp.3714 Sept-Iles Masonry Ltd.\u2014 Maçonnerie Sept-Iles Ltée.3714 3770 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 septembre 1959, Tome 91, N° 38 Sholem Corporation.3714 Sidepal Corp.37 lô Tareen Development Ine.3715 The Killarney Club of Quebec Inc.3715 The Naftali Corporation.3710 Turin Development Corporation.3716 Valduc Development Corp.3716 Valleyfield Motor Sales Ltd.(Correction).3719 Verdun Business College Inc.3717 Westmorc Realty Corp.3717 Wilfrid Chapdelâine Inc.3717 Willowdale Construction Inc.3718 Woodhaven Realties Inc.3718 World Wide Fabrics Company Ltd.3718 Liquidation, avis de: L'Association de Bienfaisance des Pompiers cle Montréal.3741 Proclamations: Concernant l'annexion d'un certain territoire à la munie.Moffet.3742 Convocation de la Législature pour l'expédition des affaires.3744 Jour d'actions de grâces.3743 Sièges sociaux: Charles E.Frosst & Co.3747 Cusson Frères General Contractors Ltd.3746 Delnor Development Inc.3745 Dorly Investment Ltd.3748 Eastern Milk Concentrates Ltd.3748 Garland Investment Ltd.3747 Gladioli Investment Ltd.3747 \\jo Club Bonaventure Inc.\u2014 Bonaventure Club Inc.3745 Leesam Holdings Ltd.3745 Majestic Investment Ltd.3747 Marsh Investments Ltd.3747 Pelnar Construction Inc.3745 Sans-Souci Investment Ltd.3748 Sidepal Corp.3746 Sparta Development Corporation.3746 Wasylyks Ltd.3746 Soumissions: Belœil, ville, comm.scolaire.3748 Lac Carré, village.3752 La Tuque, comm.scolaire.3751 Pléssisville, ville.3750 Villeneuve, ville.3754 Ventes.Loi de faillite: Dostie, Henri-Louis.3756 Lamontagne, Léon.3755 Vente par licitation: Brodeur et al vs Patenaude et al.3756 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi : Bigaouette vs Gaudrcault & Frères Ltée 3757 Arthabaska: Sholem Corporation.3, i-j Sidepal Corp.'{715 Tareen Development Inc.The Killarney Club of Quel>ec Inc.3715 The Naftali Corporation.3710 Turin Development Corporation.;, 10 Valduc Development Corp.3716 Valleyfield Motor Sales Ltd.(Correction).3719 Verdun Business College Inc.3717 Westmorc Realty Corp.3717 Wilfrid Chapdelâine Inc.3717 Willowdale Construction Inc.37 IS Woodhaven Realties Inc.3718 World Wide Fabrics Company Ltd.3718 Winding up Notices: L'Association de Bienfaisance des Pompiers de Montréal.3741 Proclamations: Concerning the annexation of a certain territory of the munie, of Moffct.37 12 Convocation of the Legislature for the dispatch of business.37 11 Thanksgiving Day.37 1 ' Head Office: Charles E.Frosst & Co.37 1 Cusson Frères General Contractors Ltd.374 Delnor Development Inc.3747) Dorly Investment Ltd.37 i Eastern Milk Concentrates Ltd.374?Garland Investment Ltd.3747 Gladioli Investment Ltd.3717 Bonaventure Club Inc.\u2014 Le Club Bonaventure Inc.371 ¦ Leesam Holdings Ltd.3745 Majestic Investment Ltd.3717 Marsh Investments Ltd.3717 Pelnar Construction Inc.37 ' Sans-Souci Investment Ltd.3748 Sidepal Corp.3746 Sparta Development Corporation.3746 Wasylyks Ltd.3746 Tenders: Belœil.town, school comm.3748 Lac Carré, village.375Î La Tuque, school comm.3751 Plessisvillc, town.3750 Villeneuve, town.3751 Sales.Bankruptcy Act: Dostie, Henri-Louis.375' I^amontagnc.Léon.3755 Sale by Licitation: Brodeur et al vs Patenaude et al.3766 SHERIFFS' SALES: Abitibi: Bigaouette vs Gaudrcault & Frères Ltée 3757 Arthabaska: Blanchet vs Lemoyne et al 3758 Blanchet vs Lemoyne et al 375S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 19th.1959.Vol.91.No.38 3771 B muahnois: Traders Finance Corporation Ltd.vs Legros.375N Bkdfori): Massé vs Roy.3759 ( 'lIICQUTIMl; Jean vs Sasseville.3759 (ÎA8PÉ: }jcs Commissaires d'Écoles de Cap-au-Renard vs Vallée.3700 Servant vs Vallée.3760 Syndics de la Paroisse de St-Martin de Rivière-au-Renard vs Rioux.3760 Hull: Interprovincial Rldg vs Constantineau .3761 Interprovincial Rldg.vs Légaré.3761 Joliette: Vachon vs Ferland et al.3762 K amour ask a: I^anglais vs Boucher.3762 Labelle: Larose vs Paré.3763 Montmagny: Talon vs Talon.3763 Montreal: Laval Pretroleum Ltée vs Tessier.3764 Quebec: Industrial Acceptance Corporation Limited vs Juneau.3764 Rimouski: Finance Locale Inc.vs Levesque.3764 Saint-Francois: Pronovost & Co.Inc.vs L'Heureux.3705 Terrebonne: Charbonneau vs Trottier.3766 Office du Crédit Agricole du Québec vs Paquette.3765 Trois-Rivières: Banque Provinciale du Canada vs La-ferrière.3766 Beauharnois: Traders Finance Corporation Ltd.vs Legros.375S Bedford: Massé vs Roy.3759 Chicoutimi : Jean VS Sasseville.3759 (Jaspé: The School Commissioners of Cap-au-Renard vs Vallée.3760 Servant vs Vallée.3760 The Trustees of the Parish of St-Martin de Rivière-au-Renard vs Rioux.3760 Hull: Interprovincial Rldg.vs Constantineau.3761 Interprovincial Rldg.vs Légaré.3761 Joliette: Vachon vs Ferland et al.3762 Kamoi h ask a: anglais vs Boucher.3762 Labelle: Larose vs Paré.3763 Montmagny: Talon vs Talon.3763 Montreal: Laval Pretroleum Ltée vs Tessier.3764 Quebec: Industrial Acceptance Corporation Limited vs Juneau.3764 Rimouski: Finance Locale Inc.vs Levesque.3764 Saint Francis: Pronovost & Co.Inc.vs L'Heureux.3765 Terrebonne: Charbonneau vs Trottier.3766 Quebec Farm Credit Bureau vs Paquette .3765 Trois-Rivières: The Provincial Bank of Canada vs La- ferrière.3706 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Quebec:\u2014Printed by Rédempti Paradis, Queen's Printer. "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.