Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 5 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1960-03-05, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 92, N° 10 1029 Vol.92, No.10 *vf/«\t\t4> \t\t \t\t] *\t\t t\t\t Drapeiu de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Quebec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QL ÉBEC Québec, samedi 5 mars 1900 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: ITmpri-nieur de la Reine.Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles» Lorsque & lle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° rayer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont stricteuunt payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° I,a Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QLEBEC Quebec, Saturday, Match 5th, 1900 NOTICE TO INTERESTED P\\RTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc.are strictly payable in advance.0.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, as second class mailable matter. 1030 GAZETTE OFF H ' IELLE DE QUÉBEC, Quebec, 6 mars WOO, Tome 92, N° 10 dé lu i pour lu réception «les avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas.l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Leg avis, documenta ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus.l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés «l'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la Seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Alionnemcnts, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes «le noms, «le chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : SO cents «les 100 mots.Exemplaire séparé:30 cents chacun.Feuilles volantes : $1 la douzaine.Abonnement : 87 par année.N.IL\u2014 Les chiffres placés au bas «les avis ont la signification suivante: Ja> premier chiffre réfèr»1 à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition «!«' la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre «l'insertions.et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni «le notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis «pie «le notre numéro «l'ordre L'Imprimeur «le ht Reine, REDEMPTT PARADIS.Hotel «lu Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 l-52-o receiving notices, documents or advert [sing copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last f the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December.1969, incorporating! Jeaa-H.Gagné, Queen's Counsel.Guy Letarte, both of Ste-Foy, and André Trotier.of Charlesbourg.all advocates, for the billowing purposes: To act as a holding company, under the name of \"Les Placements Collin Ltée Collin Investment Ltd.\", with a total capital stock of $.\"00.000.divided into 1.000 common shares of $5 each and into 49,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 22, 1st street, north.Montmagny.judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney Gênerait this twenty-ninth day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10989-59) tas Produits Chimiques Empire Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-(iovcrnor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-eighth day of December, 1959.incorporating: Camil Noël, Queen's Counsel.Chimie Rioux, both of\" Quebec, ami Jacques R.Alleyn, of Ste-Foy.all attorneys, for the following purposes: To «leal in all kinds «>f preparations and chemicals, under the name of \"Les Produits Chimiques Empire Inc.\", with a total capital stock of $50,000 divided into 400 common shares of a par value of $50 each an«l 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office «>f the Attorney Gênerait this twentv-eighth day «>f December, 1959.P.FRENETTE, 53184-0 Acting Deputy Attorney General. 1034 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 mars 19W, Tome 92, N\" 10 (P.G.14800-50) L'Oeuvre «les Terrains de Jeux des Trois-Pistoles Avis est donné qu'en vertu (le lu troisième partie de lu Loi des compagnies de Quéher these présenta, Charlemagne (ôté, merchant, Simone Dionne, housewife, wife contractually separate as to property ol the said Charlemagne Côté, and duly authorised by him for the se presents, Gabriel Hahineau telegraph-operator, Alice D'Amours Renouf, widow, housewife, Paul-Etienne Rioux, commercial traveller.Armand Gagnon, slioe-nier «\u2022haut, Raymond Morissette, joiner, Rogei Picard, delivery-man, ami Canon Louis-David Rioux, priest, pastor, all «>f Tr«»is-Pistoles.for the following purposes: To put at the disposal of youth wcll-organi/cf the Attorney General, this fourth day of January.I960.P.FRENETTE.53184 Acting Deputy Attorney General.L'Oeuvre des Vocations Sacerdotales du Diocese «le Mont-laurier Notice is given that under the provisions of the Article 20 of the Roman Catholic Bishop>' Act, 14 George VI, chapter 70, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty second day of September, 1959.incorporating \"L'Oeuvre «les Vocations Sacerdotales «lu Diocese de Mont-I aurier\".The head office of the above-mentioned corpo ration is situated in the town of Mont-I aurier Given at the office of the Provincial Secretary, on the sixteenth day of February, I960.RAYMOND DOC VILLE, 53184-0 Assist rit Secretary of the Province.(A.G.10924-59) Lucien Lufrance Inc.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1959, incorporating: Lucien Lafrance.plasterer.Yvette Grenier Lafrance.housewife, wife separate as to property of the laid Lucien Lafrance, and Emilien Martel, accountant, all of Courvillc, for the following purposes: To carry on business as contractors, under the name of \"Lucien Lafrance Inc.\", with a total capital Stock of $10.000.divided into 100 shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, i960, Vol.02, So.10 1035 Le siège sociul «le lu compagnie sera 63, rue «le Provence, ('«mrville, district jmlmiuire «le (juchée.Duté «lu burt&U «lu PnxMireur générul, le vingt-trois décembre 1959.L'Assistant \u2022procureur générul suppléant, 53184-0 1*.FRENETTE.The hcu«l office «»f the company will he at 03 Provence street, Courville, jmliciul district of Quebec.Dated ut the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1959.P.FRENETTE.63184 Acting Deputy Attorney General.P.G.17007-59) .Maid-Rite Dress Inc.Avis est donné qu'en vertu «le lu première partie «le lu Loi des compagnie! «le Quebec, il a été accordé pur le lieutenant-gouverneur «le lu province «le Québec «les lettres patentes, en «late du vingt-neuf décembre 1959, constituant en corporation: Murray B.Spiegel, «le Montréal-ouest, Samuel IL Shriar, «le St-Laurent, tous deux avocats, Mollie Schwarts et Margaret Johnson, toutes deux secrétaires, filles majeures, «le Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'habillements et vêtements «le toutes sortes, sous le nom «le \"Mai«l-Rite Dress Inc.\", avec un capital total «le $-10,000, divisé en 1.000 set tons ordinaires «le $10 chacune et 3,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district jutliciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, \u2022.3184 P.FRENETTE.(A.Cl.17007-59) Maid-Rite Dress Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issue*! by the Lieutenant-Governor of the Province «)f Quebec, bearing date the twenty-ninth day «»f December, 1959.incorporating: Murray IL Spiegel.«»f Montreal West, Samuel II.Shriar, f Bt-Laurent, both advocates, Mollie Schwartz and Margaret Johnson, both secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purgoses: To dea lin garments ami clothing of every sort, under the name of \"Maid-Rite Dress Iney, of Wcstmount.Max Hapack, of Côte-St-Luc, both advocates, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To deal in metals and the products thereof, chemicals, products of agriculture, the forest.Quarry and n ine or the sea, lakes and rivers, under the name of \"Minerals & Chemicals (1960) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1117 St.Catherine Street West, room 821, Montreal, judicial district «>f Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of Januarv, 1900.P.FRENETTE, 53184-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.16944-59) Normont Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of December, 1959, incorporating: David Goodman.Mclvin Rothman, advocates, Dorothea Calver am! Yvonne Rélanger, secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: 1087 Pain le commerce d'immeubles, sous le nom de 'Norinont Investment Corp.\", ftVCC un capital total de $10.000.divisé en 1.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la Compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-«piatre «lécemhre 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 53184 P.FRENETTE.(P.G, I700.S-.50) Onit Hiiilding Supply Ltd.Avis est «humé qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec f $10.000.divided into 1,000 shares of $10 each.The head office «>f the company will be at Montreal, judicial district ns communes «l'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Renaud, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1959.L\"Assistant-procureur général suppléant, 63184-0 P.FRENETTE.(P.G.10938-59) Professional Investment Associates, Inc.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été acconlé par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en «late du vingt-quatre décembre 1959.constituant en corporation: Carol Jones, secrétaire, fille majeure, de Westmount.Nathan Abraham Levitsky, avocat, «le Mont-Royal, et Arthur Garvis, étudiant en droit, «le Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie «le placements, sous le nom «le \"Professional Investment Associates.Inc.\".avec un capital total «le $50.000.divisé en 3.000 actions ordmaires de $10 chacune et 2.000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 57 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-«piatre décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.53184 P.FRENETTE.(P.G.10250-00) Purity Water Products Ltd.Les Produits Aqueux Purity Liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du neuf janvier 1900, constituant en corporation: Robert L.McClintock, vendeur.Vincent Ganieau, avocat, et Mlle Cécile Dernier, secrétaire, tous «le Montréal, pour les objets suivants: To deal in construction materials, store furnishings and accessories, ami particularly in all kinds of commercial refrigeration, under the name of \"Pettigrewa Manufacturing Inc.**, with a total capital stock of 840,000, divided into l.ooo common ¦hares «>f $40 each.The head office f the company will be ; I Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day f tli Province «»f Quebec, bearing date the twenty-ninth day tal capital stink of $50,001' divided into 3,000 common shares of $10 each ami 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e at 57 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office «>f the Attorney General, this twenty-fourth dav of December, 1959.P.FRENETTE.53184-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10250-00) Purity Water Products Ltd.Les Produits Aqueux Purity Ltée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quel>ec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the ninth day of January 1900, incoq>orating: Robert L.McClintock, salesman, Vincent Garneau, lawyer, and Miss Cécile Dernier, secretary, all of Mont real, for the following purposes: QUEBEC OlUClAL GAZETTE, Quebec, March Mh, 10(10, Vol.02, So.10 1039 Exercer le commerce de machines et de produits chimiques servant » purifier l'eau, sous le nom de \"Purity Water Products Ltd.\u2014 Les Produits Aqueux Purity Ltée\", avec un cupital total de «20.000.divisé en 20.000 actions de $1 chacune.Le siège social de lu compagnie sera à Montréal, district Judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1900.L'Assistant-procureur général suppléant, 1184-0 P.FRENETTE.P.G.17012-50) Quebec Reinforcing Steel Inc.Avis est donné qu'en vertu île la première partie de la Loi del compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1959, constituant en corporation: Philippe Fer tend, avocat, de Billery, Yolande Sanfa«,-on.secrétaire, fille majeure, de ( harlesbourg-Oucst, «t Jeannette Laçasse, sté-nodactylographe, fille majeure, de Québec, pour les objets suivants: Exercer le com nu rce «le matériaux de construction, sous le nom «le \"Quebec Rcinfor«'ing Steel Inc.\".avec un capital total de $100.000.divisé en 250 actions communes «le $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.l-c siège social «le la compagnie sera 1100.avenue Belvédère.Québec, district judiciaire de Québec.Daté «lu bureau du Procureur général, le '.rente décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 P.FRENETTE.(P.G.10979-59) Rapids Shopping Centre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en «late «lu vingt-neuf décembre 1959.constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en Loi, «le Mont-Royal.Charles Fric Humphrey, teneur «le livns.de Verdun, et Théodore William Martinson, commis de Montrés!, pour les objets suivants: Faire l«* commerce d'immeubles, sous le nom f $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The hea«l office of the c«>mpany will l>e at 1100 Belvedere avenue.Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.1G979-59) Rapids Shopping Outre Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day «>f December, 1959, incorporating: William Patrick (r agh.law clerk, of Mount-Royal.Charles Eric Humphrey, bookkeeper, of Verdun,and Theodore William Martinson, clerk, «>f Montreal, for the following purposes: To f the par value of $1 each.The head office of the company will be at LaSalle, judicial district «>f Montreal.Dated at the office of the Attorney General.this twenty-ninth day «>f December, 1959.P.FRENETTE, 53184-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10810-59) Rellim Uniform Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province «»f Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1959, incorporating: Louis II.Rohrlick, Queen's Counsel, «)f Westmount, Benjamin J.Greenberg, «>f Cote St-Luc.both advocates, ami Pamela Williamson, secretary, spinster, of Verdun, for the following purposes: 10-10 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql ÊBEC, Québec, 6 mars i960, Tome 92, N° w Faire le commerce l Montreal, for the following purp«>scs: To direct broadcasting and television receiving stations and to carry on business dealing in apparatus f«>r radio ami television ami electrical accessories, under the name of \"RenodifTusion Inc.\".with a total capital stock of 850,000, divided into 200 common shares «>f $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 4362 Rourhonnière street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of December, 1959.P.FRENETTE.53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10039-00) Richelieu Milk Tankers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the eighth day of January, 1900, incorporating: Raymond Lette.of Hampstead, Ixmis Yuillancourt and Hélène Gélinas, spinster of the full age of majority, both of Montreal, all lawyers, f«>r the following pur poses : To direct a milk transportation enterprise, under the name of \"Richelieu Milk Tankers Inc.\", with a total capital stock of $75.000.divided into 500 common shares f $100 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 400 Richelieu Boulevard.Richelieu, county of Rouville.judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this eighth «lav of Januarv.1900.P.FRENETTE.53184 Acting Deputy Attorney General; (A.G.10953-59) Roscmount Gas & Oil Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-eighth day of December, 1959.incorporating: Marcel Hamelin.merchant, Amlré-Lucien Ha- QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec, March 6th, 1900, Vol.92, No.10 1041 Lucien Hamelin, inspecteur, et Cécile Lisette llainclin, nuircliaiulc.épouse commune en blent dudit Marcel Hamelin, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tons de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le combustibles, sous le nom de \"Roeemount Gaa & Oil Inc.\", avec un capital total de 176,000; divisé en 2,000 actions communee oie $10 chacune et en 5.000 actions privilégiées de $10 cliacune.I/C siège social lie la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit décembre I960.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 P.PRÉNETTE.P.G.16880-60) Sagiienay Salvage Ltd.Sagiienuy Récupération Ltée Avil est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant -gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date OU vingt-trois décembre 1959, constituant en corporation: Adrien Harvey, marchand, Noëlla Savard Harvey, ménagère, épouse contractuelle- ment séparée de biens dudit Adrien Ilarvey, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous «leux d*Ahna, et .1.-Robert Kaine.gérant, de Isle Maligne, pour les objets suivants: Industrie, commerce et réparation d'instruments aratoires, véhicules et appareils à moteur, appareils électriques et matériaux de construction, sous le nom de \"Saguenay Salvage Ltd.Saguenay Récupération Ltée\".avec un capital total «le $2*0.000.divisé en 2.000 actions «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 420, rue St-.loseph.Aima, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184m P.FRENETTE.(P.G.10790-59) St-Aubin Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en date \u2022 lu seise décembre 1959.constituant en corporation: Mlle Madeleine Cliartrand.secrétaire.Guy Godard, avocat, et Louis Godard, courtier «l'assurance, tous de Ste-Agatbe-des-Monts, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles et agir comme garagistes, sous le nom de \"St-Aubin Automobiles Ltée\".avec un capital total de $40.000, divisé en 200 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $100 chacune et en 2.000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège s«)cial «le la compagnie sera à Saint-\u2022férôme.district judiciaire de Terrebonne.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le seize décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 P.FRENETTE.(P.G.10940-59) Samcy Investments Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date mehn, inipSCtor, ami Cécile Lizotte Hamelin, merchant, urife common as to property of the said Marcel Hamelin, and duly authorised by him for these présents, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in fuels, under the name of \"Roscmount Gus & Oil Inc.\", with a total capital stock «>f $75,000, divided into 2.500 common slums of $10 each ami into 5,000 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.16889 59) Suguenay Salvage Ltd.Saguenay Récupération Ltée Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1959.incorporating: Adrien Harvey, merchant.Noëlla Savanl Harvey, housewife, wife contractually separate as to property of the said Adrien Harvey, and duly authorized by Ium for these presents, both of Alma, ami J.-Robert Kaine, manager, of Isle Maligne, for the following purposes: To carry on the industry and business dealing in the reparation t»f farming implements, vehicles and motor apparatus, electrical apparatus, and Construction materials, under the name of \"Saguenay Salvage Lt«l.\u2014 Saguenay Récupération Ltée\".with a t.ital capital stock of $20.000, divided into 2.000 shares of $10 each.The head office of the company will lie at 420 St.Joseph street.Alma, judicial «llstrict of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third «lav of December, 1959.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10790-59) St- Vol.in Automobiles Ltée Notice is hereby given thut under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «)f Quebec, bearing «late the sixteenth day of December 1959.incorporating: Miss Madeleine Chart rand, secretary, Guy Gtxlurd, lawyer, ami Louis Godard, insurance broker, all of Ste-Agatbe-des-Monts, for the following purposes: To carry on business dealing in automobiles and to act as garage-keepers, under the name «)f \"St-Aubin Automobiles Ltée\", with a total capital stock of $40.000.divided into 200 common shares of a par value of $100 each un«l into 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Duted at the office of the Attorney General, this .sixteenth day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10940-59) Samey Investments Corp.Notice is hereby given thut under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty- KM2 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québee, 6 mars 1960, Tome 92, S° 10 du vingt-deux décembre 1959.constituant en corporation: Louil H.Itolirlick, conseiller de la Heine, de Westmount.Benjamin .1.Greenberg, de Côte-St-Lue.tous deux avocats, et Pamela Williamson, secrétaire, célibataire, de Verdun, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de placements, sous le nom de \"Sanuy Investments Corp.\".avec un capital total de (10,000, divisé en 100 actions ordinaires de S100 cliacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184 P.PRÉNETTE.(P.G.10922-59) Sum's Sportswear Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il u été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1959, constituant en corporation: Charles Brownstein, de Côte St-Luc.Irving L.Adessky et Moe Moscoviteb, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements pour hommes, dames et enfants, sous le nom de \"Sam's Sportswear Ltd.\".avec un capital total de $20.000.divisé en 2,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1.800 actions privilégiées de $10 chacune.Ia> siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 68184 P.FRENETTE.(P.G.1003 -6 ) Security Hardware Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1959, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, d'Outremont, Marc lieaudoin, etudutnt en droit, de Montréal, et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de ITle-l'errot, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits de fer et d'acier, sous le nom de \"Security Hardware Company\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,0 0 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal, Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184 P.FRENETTE.(P.G.16049-60) S.E.Desmarais & Cic Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1959, constituant en corporation: Gérard Desmarais, commerçant, Paul Desmarais, commis, et Jérôme Désunirais, comptable, tous de Richmond, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux- de construction, et agir comme marchand de bois, sous le nom de \"S.E.Desmarais & Cie Ltée\", avec second day of December, 1959, incorporating Louis II.Rohrlick, Queen's Counsel, of West mount.Benjamin J.Greenberg, of Côtc-St-Luc, both advocates, and Pamela Williamson, seer, tary, spinster, of Verdun, for the following purposes : To act as an investment company, under tin name of \"Samcy Investments Corp.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montr, al.Dated at the oflice of the Attorney General, this twenty-second dav of December, 1959.P.FRENETTE, 53184-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10922-59) Sam's Sportswear Ltd.Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-< Jovernor of the Province of Quebec, bearing date the twenty- third day of December, I960, incorporating: Charles Brownstein.of Côte-St-Luc, Irving L.Adessky and Moe Moscovitch, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To deal in men's, women's and children \u2022 clothing, under the name of \"Sam's Sport s\\\\.Ltd.\".with a total capital stock of 820,00 divided into 2,000 common shares of $1 t.and 1.800 preferred shares of $10 each.The head oflice of the company will be si Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10030-00) Security Hardware Company Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, healing date the thirtieth day of December, 1959, incorporating: Louis Orenstein, advocate, of Outremont.Marc Beau doin, student at law.of Montreal, and Huguett St-Marseille, secretary, fille majeure, of lie Perrot, for the following purposes: To deal in iron and steel products, under the name of \"Security Hardware Company\", with a total capital stock of $40,000.divided into 4,000 common shares of $1 each and 30.000 prcferrcl shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirtieth day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.16949-59) S.E.Desmarais & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of December 1959, incorporating: Gérard Desmarais, trader, Paul Desmarais, clerk and Jérôme Desmarais, accountant, all of Richmond, for the following purposes: To carry on business dealing in construction materials, and to act as wood merchants, under the name of \"S.E.Desmarais & Cie Ltée\", with QUEBEC.OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 5th, 19m, Vol.92, So.10 104.'{ >nt capital total «le 850,000, divisé en 200 actions ordinuires de $100 chacune et en 0,000 actions privilégiées «le $5 chacune.I e siège social «le la compagnie sera à Richmond, district judiciaire «le Saint-François.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-huit «lécemhre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 184-0 P.FRENETTE.(P.G.16434-50) Service des Loisirs St-Pie X, de Si-Mari in Avis est donné qu'en vertu de la troisième pi rtic «le la Iaù del compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant -gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentee, en «late du treize janvier I960; constituant en corporation sans capital-actions: Bruno Vincent, technicien-dentiste, Jean-Louis Léger, avocat, et André Barsby, gérant, tous de St-Martin.pour les ol.ji ts suivants: Développer les loisirs «luns la paroisse «le Saint Pie X.à St-Martin.sous le nom «le \"Service des Loisirs St-Pie X.de St-Martin\".Le montant auquel sont limités h-s biens immobiliers que la corporation peut posséder, est 8150,000.I,c siège social de la corporation sera à Saint-Martin, comté f Saint-l'ramis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day «>f December, 1959.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10424-59) Service des f.oi-ir- St-Pie X, de St-Martin Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by th«' LiciitcmuiMiovcrnor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth \u2022lay of January, 1900, to incorporate as a corporation without share capital: Bruno Vincent, technician-dentist.Jean-Dmis Ix'ger.lawyer, and André Baraby, manager, all of St-Martin.for the following purposes: To develop the leisure time in the parish of Saint-Pie X.at St-Martin.under the name of \"Service des Loisirs St-Pie X.de St-Martin\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation amy hold is t«> be limited, is 8150,000.The head office of the corporation will be at Saint-Martin, county of Laval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav «>f January, 1900.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General, (A.G.10772-59) Solid Builders Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1959.incorporating: Charles Brownstein.of Côte St-Luc, Irving L.Adessky and Moe Moseovitch.of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, and to a«-t as an investment company, under the name of \"Solid Builders Lt«L\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares «»f $10 each ami 2,000 preferred shares of $10 each.The head oflice of the company will be ut Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1959.P.FRENETTE, 53184-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10027-00) Talion & Ronapace Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have Iwen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1959, incorporating: Gerald Ryan, lawyer, Alfred Ix'clerc, accountant, both of Noranda.and Denise Corriveau, secretary, spinster, of Rouyn, for the following purposes: To act as constructors, under the name of \"Talion & Bonapace Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,500 common shares of u par value of $10 each and 2,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will l>e at Noranda, judicial district of Rouyn-Noranda. 10-14 GAZETTE OFFICIELLE DE Qt rÊBEC, Qufiher, :> mars I960, Tome 92, N\" 10 Daté du bureau du Procureur général, la trente décembre 1059.I.\"Assistant-procureur général suppléant.53184 P.PRÉNETTE, (P.G.10081-60) Trapeze Shoes Corp.A\\is est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant -gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1959) constituant en corporation: Loukl Orenstein, avocat.d'(hitremont.Marc Mcaudoin, étudiant en droit, de Montréal, et llugiictte St-Maraeille, secrétaire, fille majeure.de l'Ile-Perrot, pour las objets suivants: Faire le commerce de souliers pour hommes, femmes et enfants, sous le nom de \"Trapeze Shoes Corp/', avec un capital total «le 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3.000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le trente décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.53184 P.FRENETTE.(P.G.10029-60) Walnut Products Cor|h>ration Avis est donné qu'en vertu de la première partie «!«\u2022 la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province- de Québec «les lettres patentes, en date du trente décembre 1959, constituant en corporation: Marguerite Dadd, secrétaire, célibataire, fille majeure.Gregory Charlap, Max Slapack «-t Arthur Shulman, tous trois avocats, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le plastiques, synthétiques, laine, coton, rayonne et toute autre substance fibreuse et leurs mélanges, sous le nom «le \"Walnut Products Corporation\", avec un capital total «le $ô.000, divisé en 500 actions ordinaires de $1 chacune et 450 actions privilégiées de $10 chacune.I/C siège social de la compagnie sera à suite 20, 1374 rue Sherbrooke ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le tr< ntc décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184 P.FRENETTE.(P.O.109:10-59) W ill rot h Investment Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie f Outreinoiit.Mare Mean «loin, studcut-at-law.of Montreal, and HugÙette St-Marseille.secretary, fille majeure* ' \"Sur une motion dûment proposée, secondée et adoptée à l'unanimité, il a été résolu d'amender le règlement \\° 3, paragraphe (o) «le la Compagnie, en augmentant le nombre de directeurs de trois à quatre.Sanctionné et confirmé par un vote unanime donné à une assemblée générale spéciale «les actionnaires de '*Salc> Sites Corporation\", représentant toutes les actions émises par la compagnie, dûment convoquée pour étudier l'amende- ment dudit règlement, «-t tenu dans la «'ité de Montréal, le 18e jour de janvier I960.Le Secrétaire, 63191 HARRY 11.KLIGER.(P.G.10663-57) MONTREAL CHAPTER, THE NATIONAL SECRETARIES AssocTATION (INTERNATIONAL) Règlement \"A\" (qui augmente le nombre «le directeurs «le read as follows: \"Article IX Roard of Directors Section 1.\u2014The affairs «>f the Chapter shall be managed by a board of fourteen (14) directors (in these general by-law sometimes referred to as \"the board'*), five (5) of whom shall be tin President.Nice-President.Recording Sccretan Corresponding Secretary and the Treasurer, respectively.Section 2.The Directors shall be elected at the annual general meeting ami the procedure for their nomination ami election shall be as sel out in article XII «)f these general by-laws.\" I, the undersigned, Muriel Jeffery, Recording Secretary of \"Montreal Chapter, The National Secretaries Association (International)\" «lo hereby certified under my hand and the seal of tlie chapter that the foregoing by-law was dub enacted at a meeting of the board of directors of the chapter held on October 0th, 1959 and was duly ratified, sanctioned and confirmed by more than two-thirds of the members of the chapter at a meeting held on October 25th, 1959 and duly convened for the purpose of considering the same.(Seal) And I have signed : MURIEL JEFFERY. Ql EBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, March 5th, I960, Vol.99, No.10 1047 (P.G.10780-60) ST.LAWRENCE WAREHOUSE INC.Règlement Treize Que If nombre des directeur» de la compagnie soit augmenté «le trois (3) à quatre (4), les directe un en fonction ont le droit d'élire un directeur BUpplémentaire pour le reste du ternie «l'office, et que les règlements «le la compagnie soient amendés pour s'y conformer.Copie véritable certifiée, ce le jour de décembre 1069.Le Secrétaire, .-,.{\u2022202 ».deWOLFE MacKAY.(P.G.12649-58) LA CLINIQUE DE RÉHABILITATION POUR ENFANTS HANDICAPÉS INC.THE CLINIC OF REHABILITATION FOR HANDICAPPED CHILDREN INC.Extrait «lu règlement N° l (règlements généraux) «le la corporation ci-liaut mentionnée, tel qu'adopté à une assemblée spéciale «les membres tenue le 3 février 1960, concernant la réduction du nombre «les directeurs «le 35 à 20: \"13.\u2014 Ix* bureau de direction \u2014 Les affaires de la corporation seront administrées par un bureau «le direction composé «le vingt membres.\" Pour copie conforme Le Procureur de la corporation, 53203-O MAURICE LAXGLOIS.C.R.(P.G.11260-58) MANSIONS RADIO LIMITED Règlement sj/écial \"II\" (1958) Augmentation du nombre «le directeurs Qu'il soit et il est.par les présentes, décrété ce qui suit: 1° Ia.' nombre «les directeurs de la compagnie est, par les présentes, augmenté de trois (3) à cinq (ô); et 2.Le règlement trois, tel qu'amendé est.par les présentes, modifié pour s'y conformer.Vraie copie certifiée «l'un règlement adopté par les directeurs le 4 décembre 1958 et approuvé par les actionnaires le 4 décembre 1958 réunis en assemblée générale spéciale et représenté par 1.000 actions ordinaires et 200 actions privilégiées.Montréal, le 4 décembre 1958.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 53209-O PAUL M1GNAULT.(A.G.10780-60) ST.LAWRENCE WAREHOUSE INC.By-law Thirteen That the number of directors of the company be increased from three i'A) to four (4), the directors m office to have the right to elect the additional director for the remainder of the term, and that the by-laws of the company be amended in accordance herewith.(citified true copy, this -It h day of December, 1959.».deWOLFE MacKAY, 53202-O Secretary.(A.G.12649-58) THE (LINK OP REHABILITATION FOR HANDICAPPED CHILDREN INC.LA CLINIQUE DE REHABILITATION POUR ENFANTS HANDICAPES INC.Extract of by-law No l (general bylaws) of the above-mentioned corporation, as adopted at a special meeting of the members held Eehruary 3rd, 1000.concerning the reduction of the number of directors from 35 to*20: \"13.-The board of directors - The affairs of the corporation will be administered by a board of directors composed of twenty members.\" (fortified true copy.MAURICE LANGLOIS, Q.C., 53203 Attorney for the corporation.(A.G.11200-58) MANSIONS RADIO LIMITED Special by-law \"11\" (1958) Increase in number of directors Be it and it is hereby enacted as follows: 1.That the number of directors of the company is hereby increased from three (3) to five (5); and 2.That by-law three, as amended, is hereby amended accordingly.Certified true copy of a by-law adopted by the Directors on December 4, 1958 and approved by the shareholders on December 4, 1058 at a special general meeting and represented by 4,000 common shares and 200 preferred shares.Montreal, December 4.1958.(Seal) PAUL MIGNAULT, 53209-O Sec re t a ry -T racs u rer.P.G.11703-58) REDBROOKE ESTATES LTD.Règlement N° 27 Qu'il soit décrété et il est.par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie: 10 Que le nombre de membres du conseil, d'administration de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à cinq (3-5) et que quatre (4) d'entre eux formeront un quorum; 2° Que l'avis d'assemblée du conseil d'administration sera donné par écrit dix (10) jours francs avant une telle assemblée.3° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour concorder avec le précité.Vraie copie certifiée du règlement N° 27 «lûment décrété par les directeurs de la compa- (A.C.11703-58) REDBROOKE ESTATES LTD.By-law No.27 He it enacted, ami it is hereby enacted as a by-law of the company: 1.The number of the board of «lirectors of the company be and it is hereby increased from three to five (3-5) and four (4) of whom shall form a quorum ; 2.Notice of meeting of the board of directors shall be given in writing ten (10) clear days before such meeting.3.The by-laws of the company be and are hereby amended to accord with the foregoing.Certified true copy of by-law No.27 duly enacted by the directors of the company at a 1048 ¦nie à une assemblée tenue à Montréal, le SSe jour uY février 1000 Un règlement pour autoriser la distribution d'actif be expedient for the [impose «)f carryinj OUt ami givh g effect to the distribution i «les compagnies de Quél)cc.Daté à Montréal, ce 23e jour de février 1960.Les Procureurs de Hannonv Enterprises Ltd., 53192 SHENKER & TEITELBAUM.PRIDE OGLEN KNITTING MILLS OF CANADA LIMITED Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Pride O'GIcn Knitting Mills of Canada Charters \u2014 Surrender of HARMONY ENTERPRISES LTD.Notice is hereby given that \"Harmony Enter prises Ltd.\", a corporation constitute*! under th« Quebec Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attor ney-General of the Province of Quebec for leavt to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.' Dated at Montreal, this 23rd dav of Februarv.1900.SHENKER & TEITELBAUM, Attorneys for 53192-o Harmony Enterprises Lt«l.PRIDE O'GLEN KNITTING MILLS OF CANADA LIMITED Notice is hereby given that \"Pride O'Glcn Knitting Mills of Canada Limited\", incorporated 1049 Limited*', constituée en corporation en vertu de ,.i Loi dea compagnies de Québec, et ayant son âge social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province «le Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions «le la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 24e jour f the Province of Quebec for leave t«> surrender its charter.Me ANDRÉ BEGIN, 53196-0 Attorney for the company.HOUSEHOLD SUNDRY SPECIALTIES CO.INC.Notice is hereby given that \"Household Sundry Specialties Co.Inc.\".which has its head office in the city ami district of Montreal, in the Province of Quebec, will make application for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Quebec Companies Act.Montreal.Decembers.1959.Household Sundry Specialties Co.Inc.Per (Signed) E.A.RE1D.President.Mtres.Crestohl.Tinkoff.Seal & Crestohl.Attorneys for Petitioner, J454 Mountain Street, Montreal 25, Que.53196-0 BELLETERRE QUEBEC MINES.LIMITED (No Personal Liability) Under the provisions of the Quel ec ( Ompanies Act.as amended, \"Belleterre Quebec Mines, Limited\" (No Personal Liability), hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney-General «>f Quebec for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation and fix a «late upon and from which it shall be dissolved.Bellcterre.Quebec, December 4.1959.(Seal) F.T.M< KINNEY.53234m Secretary. 1080 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, r, mars I960, Tom,- 98, A\" to Compagnie autorisée Company Lieensed à faire «les affaires to do Business (Sec.I*.171-60) GENEPAX LIMITED Avis «si, par les présentes, donné que \"Gciiefnx Limited\") uni* compagnie à Fonda social étrangère! constituée en corporation en Angleterre, en vertu «!i des compagnies, 1008 à 1917 et de la lyoi «les compagnies, 1948, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions «le la Ix»i des compagnies à fond social étrangères, S.R.Q.1941, chapitre 270.Ix> bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à 164 aveline Metcalfe, en la cité de West mount, district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de receveur les assignations dans les procédures exercées contre elle, est M.George T.Tamaki, a/s Stikeman & Elliott.Edifice de la Banque du Canada.901 Carré Victoria, en la cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, OS 1er jour «le mars I960.Le Sous-secret aire de la province, 53184 RAYMOND DOUVILLE.(P.Sec.171-60) GENEPAX LIMITED Notice is hereby given that \"Gem-fax Limi ted\", an extra-provincial company incorporated in England in virtue of The Companies Acts 1008 to I!»I7.and The Companies Act,'1948, has been licensed to carry CO business in the Province of Quebec, pursuant to the provision: of the Extra-Provincial Companies Act, R.S.Q 1041, chapter 279.The principal oflice of the said company in the Province is to be established at 164, Metcalfi Avenue, in the city of Westmount.judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.George T.Tamaki, c/o Stikeman & Elliott, Rank of Canada Building, 901 Victoria Square, in the city of Montreal.Given at the oflice of the Provincial Secretary< this 1st day of March.I960.RAYMOND DOUVILLE, 53184-0 Assistant Secretary of the Province.Compagnies dissoutes Companies Dissolved (P.G.13-147-59) MANOR CONSTRUCTION LTD.Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la lx»i des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1041, chapitre 276, article 20.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général \"d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"Manor Construction Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, par lettres patentes en «late du 27 janvier 1958.Avis est «le plus donné qu'à compter «lu quinze février 1060, ladite compagnie a é'té dissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le seize février I960.L'Assistant-procureur général suppléant.53184-0 P.FRENETTE.(P.C.15.S4I-59) N.& A.FILM & .AMUSEMENT CORPORATION Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 276, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abamlon «le la charte «le la compagnie \"N.& A.Film & Amusement Corporation\", constituée en corporation en vertu «le ladite première parti»' «le la Loi «les compagnies «le Québec, par lettres patentes en date «lu 14 juillet 1948.Avis est «le plus donné qu'à compter du quinze février I960, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général, le seize février I960.L'Assistant-procureur général suppléant, 53I84-0 P.FRENETTE.(A.G.13447-59) MANOR CONSTRICTION LTD.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 270, R.S.Q.1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General baa been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Manor Construction Ltd.\".incorporated under the said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated January 27.1958.Notice is also given that from and after February fifteenth, I960, the said company has been dissolved.Dated at the ffioce of the Attorney General, this sixteenth dav of February, I960.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.15841-59) N.& A.FILM & AMUSEMENT CORPORATION Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.section 20, cheptel 270, R.S.Q.1911.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company\" N.& A Film & Amusement Corporation\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies Act.by letters patent dated July 14.1948.Notice is also given that from ami after Fe hruary fifteenth.1900, the sai«l company ha- been dissolved.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of February, 1900.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General. Quebec official gazette, Quebec.March 5th, torn, n, n*.w 1051 P.G.14706 58) PETIT TEXTILES LIMITED Avis est donné qu'en vertu «le lu première parti»- »le la Iaà del Compagnies »!»\u2022 Québec, Statuts refondus «le Québed 1941, chapitre 270, article 20, «-t sujet à la responsabilité décrétée par l'article -7 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon ar lettres patentes en date «lu 3 août 1056.Avis est «le plus donné «pi'à compter «lu quinse lévrier 1000.ladite compagnie a «'\"té dissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le seize février 1900.L'Assistant-procureur général suppléant.53184-0 P.FRENETTE.(P.G.1470649) CITY HOUSE FURNITURE INC.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la \\a>\\ «les compagnies «le Québec.Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte «le la compagnie \"City House Furniture Inc.'.', constituée en corporation en vertu «le ladite première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes en date «lu 17 mars 1932.(A.G.11798-59) AUTOMATION PRODUCTS INC.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies Act.section 26, chapter 270, R.S.Q.1911.and subject to the liability-enacted by section 27 of the said Act.the Attorney («encrai has been pleased to accept the surrender «)f the charter of the company \"Automation Products Inc.\".incorporated under sait! Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated August 3rd, 1956.Notice is also given that from ami after February 15th.1900.the said company has l>een dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth «lav of February, 1900.P.FRENETTE.53184 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14700-59) CITY HOUSE FURNITURE INC.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 20, chapter 270, R.S.Q.1941.ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General has been please*! t»> accept the surrender of the charter of the company \"( ity House Furniture Inc.\".incorporated under said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated March 17th.1932. 1052 GAZETTE (H F ICI ELLE DE (Jt 'fiUï.c.Québec, 6 mare i960.Tome 99, A'° io Avis est de plus donné qu'à compter «lu quince février I960, Indite compagnie i été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize février I960, L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 P.FRENETTE.Notice is also given liait from and after F» binary 15, I960 the said company has been dissolved.Dated at the oflice of the Attorney Genera this sixteenth day of February, I960.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12608-50) HUTCHISON GROCERY & PROVISIONS LTD.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 27f>, article 26, «-t sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «!«\u2022 la charte de la compagnie \"Hutchison Grocery & Provisions Ltd.', constituée en corporation en vertu «le ladite première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes en date «lu 21 février 1949.Avis est de plus donné qu'à compter «lu quinze février I960, ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le seize février 1900.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 P.FRENETTE.(P.G.1497S-59) .1.A.GOSSELIN SALES LTD.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte «le la compagnie \".L A.(îosselin Sales Ltd.\".constituée en corporation en vertu «le ladite première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes en «late du 7 février 195\").Avis est «le plus donné qu'à compter «lu quinze février 1900.ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le seize février 1900.L'Assistant-procureur général suppléant^ 53LS4-0 P.FRENETTE.(P.G.1269349) HUTCHISON GROCERY & PROVISIONS LTD.Notice is hereby given that under Part I the Quebec Companies Act.section 26, cheptei 270.R.S.Q., 1941, and subject t«» the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attoi ney General has been pleased to accept the sur render of the charter oi the company ' Hutchisoi Grocery «x Provisions Ltd.\", incorporated undei said Part I of the Quebec Companies Act, hj letters patent dated February 21st, 1949.Notice is also given that from ami aft.February 15, 1900.the said company has be< dissolved.Dated at the office the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attoi ney (ieneral has been please* 1 to accept the surrender of the charter of the company \"J.A.Gosselin Sales Ltd.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated February 7th, 1955.-Notice is also given that from ami after February 15, 1900 the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of February.1960.P.FRENETTE.53184 Acting Deputy Attorney General.(P.G.15535-59) LIDO DEVELOPMENT CORPORATION Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, Statuts refondus «le Québec.1941.chapitre 270, article 20.et sujet à la responsabilité décrété par l'article 27 «le la«lite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte «le la compagnie \"Lido Development Corp«>ration\", constituée en corporation en vertu «le ladite première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, par lettres patentes en «late «lu 23 février 1957.Avis est «le plus donné qu'à compter «lu quinze février I960, ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le seize février 1900.L'Assistant-procureur général suppléant, 531S4-0 P.FRENETTE.(A.G.15535-59) LlDO DEVELOPMENT CORPORATION Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act, section 20.chaptei 270.R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attoi ney (ieneral has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lido Development Corporation'*, incorporated undei ¦aid Part I of the Quebec Companies Act, b;.letters patent dated February 23rd.1957.Notice is also given that from and aftci February 15, 1900, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney (ieneral this sixteenth «lay of February.1900.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General. Qi ' /.7.7.Y \u2022 ol ne I.M.a.i //.r TE.Quf the con pany \"La Petite Symphonie «h- Montréal \u2014The Little Symphony of Montreal\", incorporated under Part III of the Quebec Companies Act, by letters patent dated October 20.1942.Notice is also given that from ami after Pe-braury twenty-ninth, I960, the sai«l company has been dissolved.Dated at the office «>f the Attorney General, this first «lav of March, 1960.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General.(AG.10200-59) LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DYAMASKA LIMITÉE Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 20.chapter 270.R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter «>f the company **I*a Compagnie «le Téléphone d'Yamaska Limitée', in-corporated under the said Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated November 19.1920.Notice is also given that from ami after February twenty-ninth, I960,-the said company has been dissolve «1.Dated at the office «»f the Attorney General, this first day of March, I960.P.FRENETTE, 531S4 Acting Deputy Attorney General, (A.G.1 (5903-59) INTERNATIONAL ELECTRIC ROUYN LIMITED Notice is hereby given that umlcr Part I of the Quebec Companies Act.section 26, chapter 270.R.S.Q., 1941.and subject to the liability euacte»! by section 27 »»f the sai«l Act.the Attorney (ieneral has been please*! t«> accept the sur- 106 I GAZETTE OFFICIELLE »!¦: Ql ÊBEC, Quebec 6 mars i960, Tom 99, A'° 10 généra] d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"International Electric Etouyn Limit-ad\", const it née en corporation en vertu «le ladite première partie de la Loi «les compagnie! de Québec, par lettres patente! en «late «lu 5 avril 1940.Avis est de plus donné qu'A compter du vingt-neuf février I960, ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le premier mars I960.1/Assistant -procureur général suppléant.63184-0 1'.FRENETTE.(P.G.14449-59) KAKI.P.O'MARA ft COMPANY LIMITED Avis est donné «pieu vertu «le la première partie de la Loi del compagnie! de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi.il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon «le la charte «le la compagnie \"Karl P.O'Mara Company Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, par lettres patentes en «late «lu .'I novembre 1954.Avis est «le plus donné qu'A compter «lu vingt-neuf février 1900, ladite compagnie a é'té dissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le premier mars 1900.L'Assistant -procureur général suppléant.53184-0 P.FRENETTE.(P.G.14159-58) AIR PACKER CO.INC.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 27(i, article 20.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"Air Tacker Co.Inc.\".constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la \\ah «les compagnie! de Québec, par lettres patentes en date «lu 20 avril 1955.Avis est «le plus donné qu'A compter «lu vingt-neuf février I960, ladite compagnie a été «lissoute.Daté du bureau du Procureur général, le premier mars I960, L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 P.FRENETTE.(P.G.10034-56) STANLEY ENTERPRISES INC.Avis «-st donné «pi'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte d«- la compagnie \"Stanl y Enterprises Inc.\".constituée en corporation en vertu «le ladite première partie de la Loi «les compagnies de Québec, par lettres patentes en date «lu 7 février 1950.Avis est «le plus donné qu'A compter «lu vingt-neuf février 1900, ladite compagnie a été «lissoute.Daté «lu bur au «lu Procureur général, le premier mars 19(>0.L'Assistant-procureur général suppléant, 53184-0 I».FRENETTE.render «»f the charter of the company \"Interna tional Electric Rouyn Limited', incorporate.! under the said Pari I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated April 5, 191\".Notice is also given that from the after Februa ry twenty-ninth, I960, the said company has been dissolved.Dated at the «>flioc of the Attorney (ieneral this first dav of arch.19(50.P.FRENETTE, 53184 Acting Dpeuty Attorney General.(A.G.I 1149-59) KARL P.O'MARA ft COMPANY LIMITED Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapt 276, H.S.Q.1941.and subject t«> the liability enacted by -cet ion 27 of the said Act, the Attorney 'ieneral has been pleased to accept the BU render of the charter of the company \"Karl F.O'Mara ft Company Limited\", incorporate ' under the said Pert I of the Quebec Compani.Act by letters patent dated November 3, 1954.Notice is also given that from and after !'\u2022 braury twenty-ninth.I960, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney (ieneral.this first day f March.I960.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney (ieneral.(A.G.14159-5S).AIR TACKER CO.INC.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies Act, section 2(5.chapter 270, R.S.Q., 1941.ami subject t«> the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney (ieneral has been pleased to accept the SUI render «)f the charter of the company \"Air Tacki Co.Inc.\".incorporated under the said Part I ol the Quebec Companies Act, by letters patent «lated April 20.1955.Notice is also given that from ami after February twenty-ninth, 1960, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this first day «)f March.19(50.P.FRENETTE, 531S4 Acting Deputy Attorney General (A.G.10534-50) SANTLEY ENTERPRISES INC.Notice is In reby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 2(5.chapter 270.R.S.Q.1941, ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter f the Quebec Companies Act, by letters patent dated February 7th.1950.Notice is also given that from and after February 29, 1900.the suid company has !»«\u2022« n dissolved.Dated at the office of the Attorney (ieneral.this first day of March.1900.P.FRENETTE, 53184 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec March 6th, 1960, Vol.99, \\.tO 1065 !'.f the Quebec Companies Act, section 20, chapter 270.R.S.Q.1941, and subject to the liability enacted by section 27 «if the said Act, the Attorney (ieneral has been pleased t«> accept the surrender of the charter «>f the company \"L'Association des Chevaliers de Gatincnu.Limitée\", incorporated under said Part I «>f the Quebec GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mare I960, Tome 9g, N° 10 en \\ fit n (le ladite première parti»- «le la Loi dee compagnies de Québec, par lettres patentes en date est de plus «lonné cpi'à compter du vingt-neuf février I960, ladite compagnie a été (lissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le premier mars i'.Mit).L'Assistant -procureur général suppléant, jvtivi., p i-'WK.xkttk.Companies Act, l>y letters patent dated March 1st.1946.Notice is also given that from ami after I hriiury 29, 1900, the sai«l company has been dissolved.Dated at tin- ofli»»- of the Attorney Genei this first «lav of March.I960.IV FRENETTE, 63184 Acting Deputy Attorney (ieneral.Curatelle publique Publie Curatorsbip EVAN THOMAS Succession vacante «h- Evan Thomas en son vivant messager à la banque «h- Montréal.Montréal, P.Q.Le soussigné donne avis que f Arthabasku, to the school municipality of the town of Arthabaska, same count Quebec, February 23rd, 1900.O.-.I.DESAUENTERS, 53180-9-2 Superintendent of Education.No.303-50.PARISH OF CHICOUTIMI Application is made to «letach from the scho I municipality of the parish of Chicoutimi, in tie county «>f Chicoutimi, the terrritory herebelo described, to annex it to the Catholic school municipality of Chicoutimi.in the same county A territory situated in the township «»f Chicoutimi comprising, with reference to the official cadaster of the parish of Chicoutiini, part of lot ¦¦ Nos.(>8.09.70.71.72.73 ami 74-A of Hie first range southwest Svdenham Road ami lots Nos.1-A.1-B (part).2 (part).3-A.3-11 ami 4-A of the eighth range southwest Sydenham Road and their subdivisions, comprise in the interior «>f the peremeter hereinafter described: Starting from the southeast corner of lot No.4-A, of tla-said eighth range; thence, successively, the following lines: the dividing line of lots Nos.4-A and 4-11 going towards the northwest; the dividing line of the 8th ami 9th range southwest Sydenham Road going towards the northeast; the dividing line of the ai«l 8th range ami the city of 1057 Nos 2 ti 8-A dudit 8s rang en allant vers le gud-est sur une longueur dfl 990' pi«-«|s; un ruisseau mi allant vers le nord-est; un autre ruisseau, dit \"Rivière aux Rate\", en allant dans une direction oyenne nords la ligne separative des lots Nos l-liet 2 en allant vers le sud-est jusqu'au lot de subdivision No l-B-194; la ligne separative des de subdivision Nos l-B-194 «-t l-B-195 jus-.iii lot de subdivision No l-B-4; la ligne sépa- rative des lots de subdivision 1 It-1 et L-B-194; limite nord-est du lot «le subdivision l-B-4; la .separative du susdit Be rang el la ville de « hicoutimi, en allant vers !«\u2022 nord-est; la ligne separative entre le premier rang sud-ouest Chemin Sydenham «'t la ville «!«\u2022 Chicoutimi, en allant vers le nord-est; la ligne sud-ouest des lots subdivision Nos 74-À-2-1, 74-A-2-3, 74-A-2-6, 74-A-2-7, 74-A-2-9.74-A-2-11 à 74-A-2-27 inclusivement; la limite sud-est du lot de subdivision \\o 71 A-2 27 «-t son prolongement vers le nord- -t jusqu'à la limite nord-est «lu chemin public, «lit Chemin St-Thomas; Is limite nord-est du i min St-Thomas «-t son prolongement en i droite vers le sud-est jusqu'au lot No 97; la ligne separative «les lots Nos 07 et ON, en allant vers le sml-ouest ; lu ligne separative entre !( premier et septième rang sud-ouest Chemin S denham, en allant vers le nord-ouest jusqu'à la limite nord-ouest du Boulevard Talbot: la limite nord-OUesl du Boulevard Talbot en allant ¦ rs !«\u2022 sud-ouest jusqu'au point «le départ.Ce territoire ainsi décrit contient une super-i /'»'.\u2014 l ne autre partie «lu lot originaire numéro trois cent seise (P.310) aux plan et livre «le renvoi du cadastre ofliciel de la paroisse St-Antoine «le I.ongucuil division d'enregistrement de Chambly.Bornée vers le nord-est par la rue Iliudland; vers le Btld-est par partie du M 142-232 et par le lot 310-1 19; vers le Sud-OUest par partie «lu lot 142-187 et vers le nord-ouest par le lot 142-1S7A et par partie du lot 142-ISS.Mesurant 00 pieds «le largeur et formant une superficie approximative «le 15,306 pieds carrés, mesure anglaise.Description de partir du lot Ids.- l ne partie non subdivisée «lu l«>t originaire numéro cent trente-huit (P.138) aux plan et livre de renvoi «lu cadastre officiel de la paroisse St-Antoine-de-Longueuil, division d'enregistrement «le Chambly, bornée comme suit: vers le nord-est par la rue \\«)tre-I)auie-«le-(îrace, vers le sml-est par les lots 138-1A; 138-33; 138-34 vers le sud-ouest par le lot 138-76 et vers le nonl-ouest par la rue l'erreault.Mesurant 128 pieds au nor«l-est.I3S pieds au sml-est; 12f> pieds au sml-ouest et 138 pieds au nonl-ouest.Formant une superficie d'environ 17.520 pieds cam's, mesure anglaise.Description de partie du lot ISS.\u2014 Une autre partie du lot originaire numéro cent trente-nuit (P.138) aux plan et livre de renvoi du cadastre ofliciel «le la paroisse St-Antoine «le Longueuil division d'enregistrement «le Chambly.Bornée vers le nord-est par le lot 307-3, rue Notre-Dame de Grâce; vers le sud-est par la rue Perreault; vers le sml-ouest par les lots 104-1 à 140-0 inclusive- lot 307-3N; 307-39 to 307-71.I38-I-A ami 13s ! u> 138-32; 13S-35 to 138*65; 188-67 to 138-73; I3S-75 to I3S-77 to 138-81; 138-84 to 138-116 138-118 to 138-122; 138*124 t«> 138-130; 138*132 to 138-151; 138-158 t 138-201; 138-204 to 138-223 I3S-23I to 138-235; 139-25, 139*26, 139-27, 130-58, 139-59, 139-60, 139-62 to 139-64; 140-1 t.Ill) 1; 140-6 l«.110-13; 140*15 to 110-18; 140-20 to 140-26; I 10-29.140-30, 140-31 and 110-33 to 140-65, 140 07.140*68, 140*69, 140-71 to 140-77; 140-79 t«> 140-111; 140-113 t«.110-145; 140-147 to 140-157; 140-169 t«» I 10-177; 140-179 I i 140-185; 140-187 to 140-205; 140-207 to 140-225; 110-220 to 110 231: 110-230 to 140-243; 110-265 to 110-273; 140-303 to I 10-309; 110-311 t.140-310; 140-338 to 140-346; 140*373 to 110-370; ! m 37'.' to 140*386; 140-411 to 140-418; 141-2 to 141-9; 141-32 to 141-38; 141-40.Mill.141-64, 141-65, 141-100 to 141-105; 142*23 to 142-39; I42-P40, I42-P41, 142-42 t«.142-54.I41-P56, 142-56*2, 142-57 t«.142-62; 112-104 to 142-187, 142-187A, 142-188 to 142-211; 112-211 : I 12 212-1, 112-213 to 142-222; 142*224 t«» 142-230; 142*254 to 142-276; 142-278 t.142-294; 113-288 to 143-319; 143-322 t«.143-361; 143-363 to I43-3S9; 143-391 t«» 143*469; 143-471 to 143-502; 143-505 to 113-508; 143-510 t«> 143-513; 143-5 143-517 to 143-669; 143-571 to 143-590; 143-592 to 143-598; 143-600 to 143-618; 143-020 to 113-073; 143-074.143-070-1.143-077-1.143*678 to I 13-701; 310-1 t«> 310-5: 316-149; Description of part if lot ¦ilti.\u2014 An unsulxli-vided part of the original lot number three bun dred ami sixteen (l't.316) on the official plan ami book of reference «>f the official cadaster for the parish of St-Antoine-de-Longueuil, registre (ion division of Chambly.Mounded on the northeast by the limiting line between the city of Montreal-South and the city «>f JacqUCS-t Si tier; on the southeast, by lot 142-271; on I southwest, by Iliudlaml Street, ami on the northwest by l«>t 142-272.Measuring 66 feet in width ami forming an approximate area of 16,1 square feet, English measure.Description of part of lot 816.\u2014 Another part of original lot number three hundred and sixteen (l't.316) on the oflieial plan ami in the book f reference «>f the official cadaster for the parish of St-Antoine de Longueuil, registration division ol Chambly.Bounded on the northeast by Hinil-land Street; on the southeast, by part «>f lot I I-232 ami by lot 316-149; on the southwest, by part of lot 1 -12- 1ST ami on the northwest, by lot 142-1S7A ami by part of lot 142-188.Measuiï g 00 feet in width and forming an approximate ares of 15.300 square feet, English measure.Description of part of lot 1,38.\u2014 An unsiih-divided part of the original lot one hundred and thirty-eight (l't.138) on the plan and in the book of reference of the official cailaster for the parish of St-Antoine-de-Longueuil, registration division of Chambly, bounded as follows: \"ii the northeast, bv \\«>trc-Danie-de-(irûce Street, «>n the southeast, by lots I38-1A; 138-33; 138-31.on the southwest, by l«>t 138-75 ami on the northwest, by Perreault Street.Measuring 128 feet on the northeast, 138 feet on the southeast; 126 feet on the southwest ami 138 feet tm the northwest.Forming an area of about 17.520 square feet.English measure.Description of part of lot 188,\u2014 Another part «>f original lot number one hundred and thirty-eight (Pt.138) on the plan and in the book of reference of the official cadaster for the parish of St-Antoine de Longueuil.registration division of Chambly.Bounded on the northeast by lot 307-3, Notre-Dame-de-GrAce Street; on the southeast, by Perreault Street; on the south- 1069 ment et vers le nonl-ouest par la ligne limitative entre les cités de longueuil et de Jacques-Cartier.Mesurant MM pieds au nord-est; 384 pieds au sud-est; 188 pieds au sud-ouest, formant une uperficie d'environ 73,344 pieds carrés, mesure anglaise.( e changement prendra cll'ct le premier juillet I960.Québec, le 18 février 1960.Le Surintendant de l'Instruction publique, 53208-0 O.-.l.DESAULNIERS.N° 368-69.ST-PIERRE-DE-L'ÉTANG Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Pierre-de-l'Etang, dans le comté des Ilcs-dc-la-Madclcine.le territoire (i dessous décrit pour l'ériger en municipalité scolaire distincte sous le nom de Patima, dans le comté des Iles-de-la-Madeleine.\"Un territoire situé dans l'Ile Grindstone, comprenant, en référence au cadastre ofliciel revisé en voie de préparation, tous les lots ou parties de lot et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, cette partie «le la Dune du Nord et du golfe St-Laurent, le tout renfermé Mans les limites suivantes, savoir: Partant «lu point d'intersection de la rive «lu golfe Saint-Laurent avec la ligne separative des Lis 2047 et 2049; de là.2048, 203!» et 2038, le dernier tronçon prolongé à travers le chemin public; le COté ouest du chemin public jusqu'à l.i ligne separative des lots 2034 et 2036; cette dernière ligne; la ligne separative des lots 2017 ( I 2028; la ligne séparant les lots 2023 et L024 d'un côté et 2025 et 2020 de l'autre côté et son prolongement à travers le chemin public; le côté sud-est du chemin public, limitant vers le nord-ouest les lots 883, 884, 885, 889, SOI, 892 H 893; une ligne brisée, séparant les lots 933, 934, 1039.1638, 1637, 1636, 1635, 1034, 1033.32, 1031, 1030.1029.1027.1020 d'un côté des lots 932, 981.929.837.936, 970 et 977 de l'autre cté, le dernier tronçon prolongé jusqu'à l'axe d'un chemin public: ledit axe «lu chemin public passant en front «les lots 993, 992, 991.''!'0.traversant le lot 9S0.passant en dront des lots 989, 988, 999.et 1002.traversant les lots 1014 et 1015, passant en «Iront des lots 1454, 1453, 1354, 1355.1350.1357.135S.1353, 1351, 1 1347, 1340.1345, 1329, 1330, et 1322 jusqu'au prolongement «le la ligne separative des lots 1321 et 1325; ce dernier prolongement; une ligne brisée séparant les lots 1321 et 1394 el 1303 d'un tôté «les lots 1325, 1323, 1309 et 1308 «le l'autre côté; la ligne séparant le lot 1239 «les lots 1303 et 1234 et son prolongement dans le golfe Saint-Laurent sur une longueur de six dixièmes (0.0) «le mille; puis dans le golfe Saint-Laurent les lignes imaginaires ayant les directions astronomiques et les longueurs suivantes: N.11°30'E.\u2014 Sept cent trente-trois (0.733) millièmes «le mille; N.57°30'E \u2014neuf nulle et cent soixante-sept millièmes «le- mille (9.167); S.47°00'E.\u2014 un mille et «leux dixièmes (1.2); cette dernière ligne traversant la «lune du Nord; S.32°00'O \u2014 un mille et neuf cent trente-trois millièmes «le mille (1.933); S.51°00'O \u2014 jusqu'à une ligne de direction nord-sud, passant mi-distance entre l'Ile Grindstone et l'Ile Allright; cette «lernière ligne dans la direction sud jusqu'au prolongement «le la ligne separative des lots -047 et 2049 et enfin ce dernier prolongement jusqu'au point de départ\"; Québec, le 1er mars 1900.Le Surintendant de l'Instruction publique, 53228-10-2-O O.-J.DESAULNIERS.west, by lots 104-1 to 140-0 inclusive and on the northwest by the limiting line between the cities of Longueuil ami JacqUeS-t artier.Measuring MM feet on the northeast; 384 feet on the southeast; ih8 feet on the southwest, forming an area of about 73,344 square feet, English measure.This change will take effect on July first.I960.Quebec, February 18, I960.* O.-.l.DESAULNIERS, 5320s Superintendent of Education.No.358-59.ST-PIERRE-DE-L'ÉTANG Application is made t«> detach from the school municipality «>f St-Pierre-de-l'Etang, in the county of Iles-de-la-Madeleine, the territory below described to erect it into a separate school municipality under the name of Patima, in the county of lles-de-la-Madchine.\"A territory situated on the Grindstone Island, comprising, with reference to the official revised cadaster being prepared, all the lots or parts of lot and their present and future subdivisions, as well as the roads, lakes, water-courses or parts thereof, that part of the \"Dune «lu Nord\" and of the St-Lawrence Gulf, the whole enclosed within the following limits, t«> wit: Starting from the point of intersection of the shore of the M-Lawrence Gulf with the dividing line of lots 2047 sod 2049; thence, 2048, 2039 and 2038, the last wind-gap prolongated across the public road; the west side of the public road up to the dividing line of lots 2034 ami 2035; this latter line; the «liv iding line of lots 2017 and 2026; the dividing line «>f lots 2023 and 2024 on one side ami 202\") and 2026 on the other side and its prolongation across the public road; the southeast side of the public road, limiting on the northwest lots 883, 884, 8S5.SS9, 891.892 and 893; a broken line, separating lots 933.934, 1039, 103S, 1037, 1636, 1635, 1034, 1633, 1632, 1031, 1030.1029.1627, 1626 on one side of lots 932, 931.929, S37, 930, 976 ami 977 on the other side, the last wind-gap prolongated up to the axis of the public roa«l; the said axis of the public roatl passing in front of lots 993, 992, 991, 990.crossing lot 980, passing in front of lots 9S9.988, 999, and 1002, crossing lots 1014 and 1015, passing in front of lots 1454, 1453.1354.1355, 1350, 1357.1358, 1353, 1351, 1350, 1347, 1340, 1345, 1329.1330, ami 1322 up to the prolongation of the dividing line of lots 1321 and 1325; this latter prolongation; a broken line separating lots 1321 ami 1304 ami 1303 on one side of lots 1325, 1323, 1309 and 1308 on the other side; the line separating lot 1239 from lots 1303 and 1234 and its prolongation in the St-Lawrence Gulf on a length of six/tenths (0.0) «>f a mile; then in the Gulf of St-Lawrence the imaginary lines having the following astronomical directions ami lengths: N.11°30'E.\u2014Sc\\en hundred ami thirty-three (0.733) thousandsths of a mile; X.57°30'E.\u2014 nine miles and one hundred and sixty/seven thousandsths of a mile (9.107); S.47°00 E.\u2014 a mile and two/tenths (1.2); this latter line crossing the \"«lune du Nord\"; S.32°00 \\Y.\u2014 a mile and nine hundred ami thirty-three thousandsths of a mile (1.933); S.51 WW.\u2014 up to a line in a north-south direction, passing at half/ distance between the Islam! of Grindstone and the Island of Allright; this latter line in the southerly direction up to the prolongation of the dividing line of lots 2047 and 2049 and finally the latter prolongation up to the starting point\"; Quebec, March 1st, 1900.O.-.I.DESAULNIERS, 53228-10-2 Superintendent of Education. 1060 OAZETTÊ OFFICIELLE DE Qt 'É1IEC, Québec, r, mars 19m.Tome !).'.\\° 10 N ° 90-00.BARFORD Demande foiideur «le «leux cents (2!M)) pieils.à la mesure amdais .et il est borné au nord-est par la route de l'Eglise,Ml nonl-ouest par 1 s parties dudit lot 452 appartenant l'une à Arthur Bois et l'autre à Paul-Emile Morin, au sud-est « t au sud-ouest par le résidu dudit lot 452 appartenant à Edmond Morneau.\" \"Un terrain situé dans le haut «lu second rang «le la paroisse de St-Jean-Port-Joli, comté «le l'Islet, et «lésigné au cadastre ofliciel comme partie du lot quatre cent cinquante-neuf (P.450), avec constructions et dépendances.Ce terrain mesure deux cent huit (20S) pieds «le largeur «lu nord-est au su«l-ouest sur une profondeur «le cent (100) pieds, à la mesure anglaise, et il est borné au nord-ouest et au nord-est par le résidu dudit lot 459 appartenant à Freddy Bélanger, au sml-est par les t« rn s «le Saint-Aulx rt «-t au sud-ouest par la nouvelle route 20 ou route Elgin.\" Québec, le 1er mars 1900.Le Surintendant «le l'Instruction publupie, 53230-10-2-o O.-J.DESAULNIERS.No.90-00.BARPORD Application is made to annex the present territory of the school municipality «>f Barford, in the county of Stanstcad.for taxpaying pro testants only.t«» the protestant school munii ipality of Diwille.in the c«>unty of Stansteatl.Quebec, March 1st.I960.o.-J.DESAULNIERS, 53229-10-2 Superintendent of Education.No.1222-58.ST-JEAN-PORT-JOLI Application is made to detach from tlic sel i municipality of St-Jean-Port-Joli, in the county «>f I'lslet.the part «>f hits 452 and 459of tlteofficii I cadaster «if St-Jean-Port-Joli described below.to annex it to the school municipality f Aubert, in the same county: 1.\"A lot of land, situated at the top ol I second range «d the parish f St-Jesn-Port-Ji li and designated in the official cadaster f the said lot 452 belonging one to Arthur Hois and the other to Paul-Émile Morm, on the south-east ami srutb-west by the residue of said lot 452 belonging t«» Edmond Morneau \"A lot of land situated at the top of the secoi I range of the parish of St-Jean-Port-Joli, I'lslel county, and designated in the official cadasti as being part of lot four hundred and fifty-nine (P.459).with buildings ami dependencies.This lot of land measures two hundred and eig 1 (208) feet in width from the northeast to sont' west, by a depth of «>ne hundred (100) feet, English measure, and it is bounded on the nortl west ami north-east by the residue of said lot !¦\" ' belonging to Freddy Bélanger, on the south-east by the lands of Saint-Aubert and on the southwest by the new route No.20 or Elgin road.\" Quebec, March 1st.1900.O.-J.DESAULNIERS.53230-10-2 Superintendant of Education.Département des Terres et Forets AVIS Cadastre officiel «le la paroisse «le Ste-Geneviève (municipalité de ville de Picrrefomia), division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné qu'une partie «lu lot 197-25 est annulée en vertu de l'article 2I74A «lu Code civil.Québec, le IS février I960.I.e Département des Terres et Forêts.Service «lu Cadastre.1^»' Sous-ministre.53185-0 AVI LA BEI) A RI).Department of Lands and Forest NOTICE Officiai cadastre «>f the parish of Ste-Genevié (municipality of town of Pierrefonds), regis tration division «)f Montreal.Notice is hereby given that a part of lot 197-25 has been cancelled in virtue of Article 2174A l the Civil Code.Quebec, February 18, 1900.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch.A M LA BÊDARD, 53185-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 5th, 1000, Vol.02, No.10 1001 C&dflttre Officiel «le lu paroisse (le St-Eustache (municipalité de ville de St-Eustache sur le tac), division d'enregistrement f town of St-Eustache sur le Lac), registration division of Deux-Montagnes.Notice is hereby given that lots 84-9 to 84-13, 80-2 et 86-3 are cancelled in virtue of Article 217 IA of the Civil Code.(iucl.ee.February 11, 1900.Department of Lands ami Forests, ( adastral Branch, AVI LA BÉDARD, 53185-0 I >«'put y-M i inster.Oacial cadastre of the parish of St-Laurent (municipality of city of Montreal), registration division of Montreal.Notice is herein' given that lots 346-9 to 34642, 350-23 to 350-41.350-62 to 350-97, 350-109 to 350-129.350-132 to 350-140.350-159 to 350-204, 350-291 to 350-294.350-296 to 350-422, 350-448 to 350480, 350-606 to 350-021, 350-047 to 350-057.350-059 to 350-074.350-700 to 350-710, 350-712 to 350-725 and a part of lots 340-1.340-2, 340-0, 340-7, 340-8, 340-33.350-18 to 350-22, 350-42 to 350-45, 350-54, 350-58 to 350-61, 350-98, 350-99.350-102.350-1 OS, 350-130, 350-141 to 350-158, 350-265, 350-290, 350-295, 350-423, 350-581, 350-058 and 350-711 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 12, 1900.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 53185-0 Deputy Minister.Official cadastre of township of Stoke (municipality of town of Bromptonville), registration division of Richmond.Notice is hereby given that the Islands Nos 1 to 11 (Iles de la rivière St-François) are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 10, 1900.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 53185-u Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION Plombiers \u2014 Région de T rois-Rivières L'honorable Antonio Ihrutte, Ministre du Travail.d«>nnc avis, par les présentes, conformément aux dispositions «le la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), que les parties, contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers «le plombier, poseur d'appareil de chauffage, de réfrigération et gicleurs, soudeur, fcrblantier-couvreur et mécanicien en isolement «l'amiante dans la région de Trois-Rivières, rendue obliga-toire par le décret numéro 338 «lu 11 mars 1948 «\u2022t amendements, |ui ont présenté une requête à l'effet d'amender ledit décret, dans sa teneur modifiée, «le la façon suivante: 1° L'article III stra remplacé par le suivant: \"III.Taux de salaires minima: a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés pour chacun des métiers ci-après: Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT Plumbing trade \u2014 Region of Trois-Ririères The Honourable Antonio Barrette, Minister «)f Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 1(53 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the plumbing, steamfitting, refrigeration, sprinkler fitting, welding, tinsmithing-roofing and asbestos insulation trades in the region of Trois-Rivières, rendered obligatory by the decree number 338 of March 11 tli, 1948 and amendments, have petitioned him to amend the said decree, as amended, as follows: 1.Article III will be replaced by the following: \"III.Minimum rates of wages: a) The following minimum rates «>f wages shall be paid for each of the trades mentioned hereinafter: GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars I960, Tom 99, \\° w 1062 Plomba r.poseur d'àppari ili «le chauffage et accessoires, d appan ili «le réfrigératioii et gicleurs, soudeur à l'oxygène et à l'éh etrieité, frrhl ntur couvreur, mécanicien en isolement d'aiiintc, couvreur de gravier, de papier avec goudrt n et «\u2022ouverture d'asphalte: Salaires horaires Entrepreneur (services personnels).$3.00 Au 1er avril 1961.3.40 Senior Junior ( lompagnon.Si .SO SI 55 Au 1er juin I960.1.85 1.60 Au 1er avril 1961 .1.90 1.65 Au 1er octobre 1961 .1.95 1.70 Au 1er avril 1962 .2.00 l 75 An 1er octobre 1982 .2.05 1.80 in employeur ne peut rémunén ran taux prévu pour un compagnon junior plus d'un (1) s; I rié par cinq '5) sal.niés rémunérés au taux de (.i- pagnon senior ou par fraction «le ce nombre.1ère Jème .lètnc .'fènie année année année aino'e \\pprenti .80.75 80.90 SI 00 SI 10 Au 1er avril 1961 .0.80 0 05 1 05 1.15 Au 1er avril 10(i2 0 85 1 (K) 1 10 1.20 Journalier.1 15 An 1er avril 1961.1 20 Au 1er avril 1002.1.25 Aucun employeur ne peut employer plus d'un (h apprenti pour chaque compagnon à son emploi.Couverture i, rien n'empêche un ou plusieurs en 11 yeura ou une association d'empli yeurs d'étal I r ou de maintenir par accords il «1 vidu* Is DU each journeyman is his employ.Gravel, tarrc«l paper ami asphalt roofing: Certificate*! jtiurneyman.$1 75 From April 1, 1901.1 80 From April 1, 1902.I 85 Common workers working for gravel, tarred paper and asphalt roofers.1.45 From April 1, 1961.1.50 From April 1, 1902.1.55 No employer may hire mora than five (5) common workers or fraction thereof to each qualified en pi yee./') Fui.suant to section 13 of the Act.an\\ employer or association f February I960, the rcsponsability of settling all the outstanding claims in this Province of \"Security Insurance (\"ompany of New Haven\"; Whereas \"Security Insurance Company of New Haven\" has otherwise complied with all provisions of section 103 «>f the Quebec Insurance Act ; Consequently, notice is hereby given that the registration of \"Security Insurance (\"ompany of New Haven\" Is cancelled as from the 12th of February I960.Given at the oflice of the Insurance Branch, Department of Finance, the 27th of February I960.For the Minister of Finance «»f the Province.GEORGES LAFRANCE, 53200-10-2-O Superintendent of Insurance.Sièges sociaux Head Offices (P.C.11685-58) M EG ANTIC KNITTING LIMITE I) Règlement S° 18 ( onccrnant le changement du bureau principal I.c bureau principal de la compagnie \"Megantic Knitting Limited\", est transporté de la ville de \\ ictor'iaville où il était auparavant à St-Ilyaeinthe au coin des rues Bourdages et Bourassa.Copie certifiée «lu règlement N° 18 adoptée à une assemblée «les directeurs tenue le 14 août et approuvé à l'unanimité à une assemblée générale spéciale «le la compagnie tenue le 21iènie jour du mois d'août par les actionnaires détenant entre eux (100%) «les actions représentées à cette assemblée.Le Secrétaire, 53197-0 (Signé) D.MASSICOTTE.UNITED CUTTING DIES LTD.Avis est donné «pie la compagnie \"United ( nt t ing Dies Ltd.\", «'«instituée en corporation par lettres patentes datée «lu lô décembre 1959 «t avant son bureau principal à Fort Chambly.''ans le «listriet «le Montréal, a établi son bureau au numéro 27B de la rue St-Georges.A compter «le la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme \u2022tant son bureau principal.Daté à Montréal.«\u2022«\u2022 lOiènu- jour «le février I960.53199-0 MAR( ELLIN MERCIL.SCRAP & SURPLUS LTD.Avis est par les présentes donné que \"Scrap « Surplus Ltd.\", compagnie constituée en corporation par lettres patentes le lie jour de sep- (A.C.11685-58) MÊGANTIC KNITTING LIMITED By-laic So.18 Concerning the change «if the head office The head office of the company \"Megantic Knitting Limited\", is transferred from the town of Victoriaville where it was heretofore at St-Hyacinthe on the corner of Bourdages and Bourassa St reets.Certified copy of by-law No.18 adopted at a meeting of the directors on August 14, and uni-mously approved at a special general meeting of the company held on the 21st day of the month of August by the shareholders holding between them (100%) of the shares représente»! at this meeting.(Signed) D.MASSICOTTE, 53107 Secretary.UNITED CUTTING DIES OTD.Notice is hereby given that \"United Cutting Dies Ltd.\", company incorporated by letters patent on December loth.1959 ami having its head office in Port Chambly.district of Montreal, has established its oflice at 27B St-Georges Street.Prom and after the date of this notice, the sait! office shall Ik- considered by the «'ompany as being the head office of the company, Dated at Montreal, this 10th dav of February I960.53199-0 MARCELLIN MERCIL.SCRAP & SURPLUS LTD.Notice is hereby given that \"Scrap & Surplus Ltd.\", company incorporated by letters patent «m the 11th «lay of September.I9\">S, and having rO06 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql 'ÊBEC, Quitte, 0 mare Î960, Tome 9*.A'0 10 tendue 1958.et ayant s77 avenue Vail Morne.M «tut irai Montréal.26 lévrier I960.(Sceau) Le Préaident, 63204 NATHAN BIER.QUEBEC POP CORN INC.Avil est donne «nie la < Ompagiiu- \"Quebec Pop Corn Inc.'*.constitué» i n corporation en date «lu 24ième jour de iiovcmhn 1958, et avant KM1 bur< au principal dans la I ïité «le Québec, a établi son bur au au numéro 1090, llir the pur-chase of an issue «if S779.500.00 «)f bonds of the town of Beaconsfii Id, county of Jscques-Carti«r, dated April 1st, 1900 and redeemable serially from April 1st, 1901 to Apr 1 1st, 1980, inclusiv.ly, with inters st at a rate not less than h\\-f/0 ror more than 6% per annum, pi yablc sen i-annu; lly on April 1st and October 1st of each yesr.The rate of interest may be the same for the wh le issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos.: 190 \u2014 SI 37.500.00 \u2014 Paving works; 191 \u20148161,000.00 \u2014 Paving works; 192 \u2014 $30.000.00 \u2014 Sidcwi Iks aid paving works; 197 \u2014 $323.000.00 \u2014 Waterworks, sewers and pavings; 204 \u2014 $30.700.00 \u2014 op«nirg of street; 205 \u2014 $91.500.00 \u2014 Improvement of s stream.For*adjudication purposes only, interest shall be calculated as from April 1st, 1900. QI'EliEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 6th, i960.Vol.9t, No.10 10(17 he tal'l an daiiioitisst-int-iit est le suivant: Tableau tl'uinorlis.scinciit - 9179,600 JM) \u2014 OHM Année Capitol let avril 1061 .S 21.000.00 1er avril 1962 .22,000.00 1er avril 1963.23.000 00 li r avril 1001 .26,000.00 1er avril 1966.26,600.00 1er avril 1966.27.500 00 1er avril 1987 .28,000 00 1er avril 1968 .30.000 00 1er avril 1969 31.000 (M) 1er avril 1970 33,500 00 1er avril 1971 .35.000.00 1er avril 1972 .36,500.00 1er avril 1973 .39.0(H) 00 1er avril 1971 .41.000 00 1er avril 1975 .13.000 00 1er avril 1970 .-14.00(1 00 1er avril 1977 .46.000 oo 1er avril 1978 .48,500 00 1er avril 1979 .\"il,000.00 1er avril 1980 .129.000 (M) De plus, dee soumissions pourront être envoyées ¦ t seront considéré* s pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois tern es.[/adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s*< ngage à payer les obligations! capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par < hèque visé, ps vahle au pair à Pointe-Claire.Le capital et les intérêts sont payabli - à toutes les suceur sa li s dans la province de Québec, de la banque dent le nom est mentionné dans la procédure demi runt; aussi bien qu'au bureau principal ont émise s à courte échéance vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourrent, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus «le Québec, 1941, être rachetées par anticipation, in tout OU en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel radiât est parti» I.il affectera les échéances les plus éloigné» s et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à V ', du montant de l'emprunt et devra spécifier si le pr'x offert comprend ou ne comprend pas \\< s intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du Conseil qui sera tenue lundi, 21 mars I960, à 8.00 heures p.m., à l'Hôtel de Ville, 7Ô0 Chemin Lake Shore, Bcaconsfu Id.comté Jacques-Cartier.Le Conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Heacensfit Id (Comté de Jacques-Cartier), ce 1er mais 19(10.Le (ïreffier, ALEC GRIGG.Hôtel de Ville, 750 Chemin Lake Shore, Beaconsfield, (Jacques-Cartier), P.Q.Téléphone: OX 7-4000.53282*0 The table of r< dcinption is as follows: leur\t( 'apital April 1st.1901\tI 21,.1 on April 1st.1962\t22.000 00 April 1st.1963\t23.000 00 April 1st, 1901 .\t25,000 oo April 1st, 1985 .\t.25,500 oo April 1st.1900.\t27,500 00 April 1st.1907\t28.000 00 April 1st.1968\t.30.000 00 April 1st, 1969 .\t.31,000 00 April 1st.1970 .\t.33 500 00 April 1st.1971.\t35.000 00 April 1st.1972\t.30.500 00 Apr 1 1st, 1973.\t.39,000 oo April 1st.1974 .\t11.000 00 April 1st.107Ô .\t.43,000 oo April 1st.1976.\t11 000 00 April 1st, 1977 .\t46.000 oo April 1st.197S.\t48,500 oo April 1st, 1979.\t.51,000 00 April Is'.1980\t.129.000.00 Moreover, tenders may be forwarded and ¦hr-ll be cons'der () 00 April 1st.1902.x 36,500.00 April 1st.1903.x 38,500.00 April 1st.1964.x 41,000.00 April 1st, 1905.5.000.00 April 1st, 1900.5,500.00 April 1st, 1907 .0.000.00 April 1st, 1968 .0.000.00 April 1st.1969.0.500.00 April 1st, 1970.7.000.00 April 1st, 1971 .7.500.00 April 1st, 1972 .8,000.00 April 1st, 1973.8,500.00 April 1st, 1974.9.000 00 April 1st, 1975.9,500.00 April 1st.1970.10.000.00 April 1st.1977.10.500.00 April 1st, 1978.11.000.00 April 1st, 1979.12.000.00 April 1st.1980.12,500.00 The \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $152,069.40, granted by the Provincial Secretary and payable in 4 instalments of S38.017.35 each, from 1961 to 1904 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Moreover, tenders may be forwarded and shall be considérée! as ten-year short-term bonds and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considère»! for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal am! accrued interest if any.by certified cheque payable at par at Joliette.Capital ami interest are payable at all branches in the Province of Quebec, of the bank whose name is mentioned in the loan procedure, as well as at the hea«l office of said bank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation prior to April 1st.1967 inclusively, if issued at ten-year short-term, prior to April 1st.190S inclusively, if issued at fifteen-year short-term and prior to April 1st, 1970 inclusively, if issue»! for a term of 20 years, after these dates, the said bonds are, under the authority of < 'hap- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quel,,.: March 6th, I960, Vol.99, No.W 1060 dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus «le Québec, 1 ï>i 1.être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel radiât est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées el les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'iui chaque accepté égal à lr, du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offi rt comprend ou ne comprend pas I s intérêts courus sur li s obligations au moment de l< Ur livrais» n.I, g soumissions si ront ouv.ries et considérées à une séance uth, Joliette.county e>f Joliette.The se-heml commissioners do mit bimi to accept the highest or any e»f the- te-mlers.Joliette (County of Joliette), March 2nd.I960.EUGENE USSIER.Se-e-n-tarv-Tn asun r.Postal aelebess: P.O.H.21.133 S».Barthélémy Street Se.uth.Joliette.(Joliette), P.Q.Telephone: PL-3-3990.53236-0 CITE DP LONGUEUIL (( ointe de < han bly) Avis publie- est par les présentes dorné epie eles soumissions cachetées e-t endossées \"Soumissions pour obligations\" sere nt reçues p; r le- soussigné L.-P.Gagnon, secrétaire-trésorier, Hôtel ele Ville.100 ouest, rue St-Charie s, Le ngueuil, comté de Chambly, jusqu'à 8.30 heures du soir, luneli.I.-1 mars 1900.pour l'achat eh- S38o.000.00 d'obligations «le lu cité de Longueuil, cou té de Chambly, datées du 1er avril 1960 et remboursables par séries élu 1er avril 1901 SU 1er avril 1 ¦\u2022\u2022>'» inclusivement, a vie- intérêt à un taux non intérieur à 5J ¦/.e n' supérieur à G°/c par année, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunts Nos: 559.tel qu'amendé |>ar 565 \u2014 $26,000.00, travaux dégoûts, d'aqueduc, eh- pavage, de tretttoirs et d électricité; â(i7 \u2014 818.0O0.00.tel epic modifié, travaux d'égouts, ele pavage- et «h- trottoirs; 509\u2014 18.500.00, travaux de pavage; 577 \u2014 847.000.00.achat d'équipement; 579 \u2014 8150.000.00.travaux d'égouts et d'aqueduc; 589 \u2014 810.000.00.travaux ele pavage, el'aepieelue- et de trottoirs; ân4 \u2014 82.500.00.te-1 epie modifié, et instruction «!s ilans la province de Quéhe-c de la le mpie dent le nom «-st mentionné dans la procédure d'en pri nt.ainsi qu'au bureau principal de I: elite- bj nque à Toronto.Lsdit' s obi gati< ns ne sen nt pas rachetables par enticipatien avant le 1er avril 1007 inclu- siveii ent si ell s si nt émises à courte échéance dix ans.a vent le 1er avril 100S inclusivement si elles s« it émises à courte échéance epiinze- ans, ou avant le 1er avril 1070 inclusivement si elles sont én is< s pour le terme «le vingt ans; après ces «I; tes.1 selites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1011.être rachetées par anticipât ion.en tout «m m partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera I ;\u2022 éel é lues lis plus éloigné, s et les nun éros h s plus f S30.250.00 each from 1001 to 1003 inclusively, will be- received ans spplied to the service eif the saiel loan.Moreeive r.tenders may be forwarded anel shall be- e-e-nsiele r-el as ten-year she.rt-tcrm anil fif- teen-yesr short-term bonds.However, tenders shall be considered for one e>f the three terms only.Adjudication shall be made according to law*.The successful tender «I agrees to pay feu- the bonds, principal anel accrued interest, if any.by e-.rtifictl «I eque pa vablc at par at Druininemel-ville-.Capital ami intern st arc payable at all branches in the- Province of Quebec eif the bank mentioned ill the loan | re e e ellire-.The- said bonds will not be redeemable by anticipation prior te> April 1st, 1007 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior to April 1st.1968 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, anel prior to April 1st, 1070.inclusively, if issued fen- a twenty-year term, after which dates the betnels an-, under the authority of chapter 212.Revised Statutes of Quebec, 1941, subject tei be redeemed by anticipation, in whole eu- in part, at par.at any interest maturity elate: however, in case- of partial re-elcii pliem.the beiiiels to be- redeemed will be called for p.- yment in reverse einle-r e»f maturity ami serial number.Each tender must be accompanied by a e-er- tificel e-le-e(ue- (epial tei \\% of the amount of the prisent \u2022\u2022-ne anel must specify Whether in-te-rest accrued on the- bonels te) the elate- eif their delivery is included eir not in the prier e)f the tender.The te-nele is will be- eipe-ncel anil considered at a meeting of the- se-lmed commissioners te) bi- helel on Monday; March 21st, 1000.at 7.00 o'clock p.m., at the public hall, at St-Cyrille-de-Wendov-e-r.county eif Driiinmemel. !()72 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec r, murs i960, Tom 99, N 10 Les «'oiMiiiissaircs se- re'-se-rve-nt le droit «I»' D'accepter ni la plus liante ni aniline des soumissions.St-Cyrille-de-Wendover, (Comté «le Drummond).ce mars 1900.Le Sécrétai re-t résorier, L.JOYAL, N.F.St-( !yrille-de-Wendover, I Drummond), P.Q.Téléphone: 102.53238-0 VILLE DE N ICTORIA VILLE (Comté d'Arthahaska) Avis public est par les présentes donné «pie des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné Raymond Beaudet, greffier, Hôtel de Ville, Victoriaville, comté d'Arthahaska, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 21 murs I960, pour l'achat de $495,000.00 d'ol.ligations de la ville de Victoriaville.comté d'Arthahaska.daté» s du 1er avril I960 et remboursables par séries du 1er avril 1961 au 1er avril 1980 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à \u2022\">' /ni supérieur à 91% par année, payable semi-annuellement les 1er avril cl 1er octobre de chaque année.Le- taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 77 N.S., tel que modifié travaux d'égouts et d'aqueduc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1960, lx- tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $495,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1961.$12,000.00 1er avril 1962.13.000.00 1er avril 1903.14.000.00 1er avril 1904.15.000.00 1er avril 1905.16.000.00 1er avril 1000.17.000.00 1er avril 1967.18,000.00 1er avril 1968 .20.000.00 1er avril 1909 .21.000 00 1er avril 1970 .22,000.00 1er avril 1971 .24.000.00 1er avril 1972.20.000.00 1er avril 1973.2S.000.00 1er avril 1974.29.000.00 1er avril 1975 .31,000.00 1er avril 1970.33.000.00 1er avril 1977.30.000.00 1er avril 1978 .38,000.00 1er avril 1079 .40.000.00 1er avril 1980 .42.000,00 De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conforménent à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Victoriaville, comté d'Arthahaska.Ix\" capital et les intérêts sont payahh s à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au hurt au principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er avril 1907 inclusivement si elles sont émises, à courte échéance dix ans, avant le 1er avril 1968 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, OU avant le 1er avril 1970 inclusivement si elles sont émises pour le terme de vingt ans; après ces The COmmissioni rs do not hind themselves to accept the higlu st or any of tl c tenders.St-Cyrille-de-Wendover, (County of Drum* mond), March 3rd.1000.L.JOYAL, NR.Secretary-Tre asurer.SM!yrille-de-Wendover, (Drummond), P.Q, Telephone: 102.53238 TOWN of VICTORIA VILLE (County of Arthahaska) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Raymond Beaudet.clerk.Town Ball, Victoriaville, county of Arthahaska, until S.00 o'clock p.m.Monday, March 21st, I960, for the purchase of an issue of $495,000.00 of bonds for the town of Victoria-ville, Artliabaska county, dated April 1st, I960, and redeemable serially from April 1st, 1001 to April 1st, 1980 inclusively, with interest at a rate not less than 5' /, nor more than 0', pel annum, payable .semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest n ay be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law NO.77 N.S.as altered \u2014 work on sewers and aqueduct.For adjudication prupOBCS only, interest shall be calculated as from April 1st.1000.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $495,000.00 \u2014 90 year.Year Capital April 1st.1001.$12,000.00 April 1st.1002.13.000.00 April 1st.1003.11.000 00 April 1st.1004.15.0(H).00 April 1st, 1005.10.000.00 April 1st.1900.17.000.00 April 1st.1907.18.000.00 April 1st.190S.20.000 (H) April 1st.1909 .21.000.00 April 1st.1970.22,000 00 April 1st, 1971.24,000.00 April 1st, 1972.20.000.00 April 1st.1073.28.0(H) (H) April 1st.1974.29.0(H) 00 April 1st.1975.31.000.00 April 1st.1970.33.000.00 April 1st.1977.30.000(H) April 1st.197S.38.000 00 April 1st.1979.40,000.00 April 1st.1980 .42,000.00 Moreover, tenders may he forwarded and shall he considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However,tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall he made according to law.The successful tenderer agrees tei pay for the hennis, principal and accrued interest, if any.by e-ertifieel cheque payable at par at Victoria-ville, Arthahaska county.Capital and int< r st are- payable at all branches in the- province of Quebec eif the bank mentioned in the- loan procedure, as well as at the head office eif the- saiel bank at Teireintei.The saiel bonds will not be reelecmablc by anticipation prieir to April 1st.1967 inclusively, if issued as ten-year short-term beinels, prior to April 1st, 1908 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, anil prior to April 1st, 1970 inclusively, if issued for a twenty-year term, after which elates the- bonels are, uneler the QUEBEC OF Ilei.\\1.GAZETTE, Quebec, March 6th, 1960, Vol.'¦>:.So.id 1073 dates, lesdites obligations | émirent, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts retondus de Québec, 1911.être rael etées par anticipation, he- redeemed will be called for payment in reverse order of maturity ami sc rial numbe r.Each tender must he- accompanied by a certified cheque equal tt hind itself to accept the highest or any e>f the tenders.Victoriaville-, (County e>f Arthahaska), March 3rd, I960.RAYMOND BEAUDET, Clerk.Town Hall.Victoriaville, (Arthahaska).P.Q.Te 1 phone : PL 2-5529.53239 Vente \u2014 Loi de faillite Province de Québec, district de Joliette, Cour Supérieure, N° 773 (1959) \"En faillite\".Dans l'affaire ele la faillite ele: FERN AND VILLENEUVE, St-Donat.Québec, débiteur et .L-A LE X AND RE DANSEREAU, syndic.Avis de vente A\\is public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: \"Désignation: Un certain emplacement étant situ, dans la municipalité de St-Donat et composé d'une partie du lot numéro un ele la subdivision du lot numéro vingt-sept (27-1 -Pue) elans le troisième rang du canton Lussier, au cadastre ofliciel du canton Lussier, division d'enregistrement Montcalm.Ledit emplacement étant borné comme suit: Vers le sud-ouest par le chemin Coutu; en arrière vers le nord-est par une partie du lot 27-1; vers le sud-est par la rue étant une partie du lot N° 27-1; vers le mml-emest par une autre partie élu lot N° 27-1 : mesurant cent pieds (100.0') en «ront et en arrière dans ses lignes sud-ouest et no-el-est par une profondeur de cent quinze pieds (115.0') dans ses lignes nord-ouest et sud-est.Contenant une superficie d° on/.c mille quatre cent epeatre-vingt-elix-sept pieels ear-é-s (11,497 p.c.).\" ^ Sera vendu, en vertu d'un jugement de la Cour Supérieur:», pour le district ele Joliette (en faillite) rendu le 7 décembre 1959, à l'enchère publique suivant la Loi, pour ladite vente avoir I effet du décret forcé au tenue du cxle ele pro-cédures civiles, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Donat, JEUDI.le TRENTE-ET-UNIÈME jour ele MARS 19(50, à ONZE heures de l'avant-midi.Conditions: Comptant.En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer les droits du gouvernement de 2V$% conformément à la Loi.La mise à prix sera de $2,000.00.Sale Bankruptcy Aet Province of Quebec, district of Joliette, No 773 (1959).In the Superior Court, (In Rank ruptcy).In the matter of: FERNANI) VIL LENÈUVE.St-Donat.Quebec, debtor, and J.ALEXANDRE DANSEREAU, trustee.Notice of sale Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit : \"Designation: A certain emplacement being situated in the municipality of St-Donat and composed e>f a part of lot number one of the Subdivision of lot number twenty-seven (27-1-Pt.) in the thirel range of the township of Lussier, on the official cadaster e>f the township of Lussier, registration division of Montcalm.The said emplacement being bounded as follows: on the southwest by the Coutu Road; in rear, on the northeast, by a part of lot 27-1; e-n the southeast, by the street being a part of le.t No.27-1 ; on the northwest, by another part e>f lot No.27-1; measuring one hundred feet (100.0') in front and in rear in its southwest lines anel northwest by a elcpth e>f one hundred and fifteen feet (115.0') in its northwest anel southeast lines.Containing an area of eleven thousand four hundred and ninety-seven square feet (11,497 sq.ft.).\" Shall be sold under juelgment of the Superior Court, fe>r the district e>f Joliette (in bankruptcy) rendered on December 7, 1959, by public auction accoreling to law, anel the saiel sale to have the effect of a sale by Sheriff in the terms e>f the Code of Civil Procedure, at the parochial church door of the parish of St-Donat, THURSDAY, the THIRTY-FIRST of MARCH, 1900, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Conditions: cash.Over anel above the purchase price, the purchaser shall pay a Government tax of 2J-£% pursuant to the law.The upset price shall be «2,000.00. 107-1 GAZETTE of l- ICI ELLE DE QUÉBEC, Quitte, 6 mon I960, Tome 92, X\" w Pour autres renseignements, et cahier dei charges, s'sulrcsser à J.-\\lex\"intlre Danse reau, syndic.Daté à Mont u moins; borné en front par le boulevard Levesque; du côté sud-ouest par le lot N° 40-1 dudit cadastre; en arrière et du côté nord-est par d'autres parties dudit lot X° 46-2: avec la maison dessus érigée portant le N 4555 du boulevard Levesque et autres bâtiments dessus érigés avec les servitudes actives et passives s'y rattachant; II.Un autre emplacement, situé à L'Abord-Plouffe, boulevard Levesque, et composé comme suit: 1 ° D'une lisière de terre faisant partie du lot connu et désigné sous le numéro quarante-huit (ptie 48) sur le plan et au livre «le renvoi officiels de la paroisse de St-Martin; mesurant cent huit pieds de largeur en avant et cent un pieds et quatre pouces de largeur en arrière par deux cent BOUDRIAS VS BOUDRIAS ET AL Canada, Province of Quebec, district f Montreal.Superior Court No.487 572.Ihi Dard Boudrias, plaintiff; vs Dame Cécile Ledui Boudrias et al, défendants.Notice of licitation Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Mi.in real, in the district of Montreal, and rendered by the Honourable .bulge Hector Perrier.on the 8th day of February.I960, in a case in which Bernard Boudrias.constable, of L'Abord-à- 1 Moufle, district of Montreal, is plaintiff, and Dame Cécile Ledm-, widow of Aimé Boudrias.of L'Abonl-à-Plouffe.«listri«-t of Montreal, Aimé Boudrias, son, of L'Abord-à-Plouffe, «listri«-t of Montreal.Francois Boudrias.of Laval-des- Rapides.district «>f Montreal, Pierre Boudrias, of Sherrington, district «>f Iberville, Alexandre Boudrias.of Verdun, district of Montreal, Dame Bert he Boudrias, wife contractually separated as to property of Léo-PsUll Gauthier, ami the latter party by these presents to authorize his said wife by the presents, both of Drum-mondville, district of Arthahaska.Miss Lise Boudrias, teacher, spinster of the full age of majority of L'Abord-à-Plouffe.district of Montreal, and Dame Jeanne «l'Arc Boudrias.wife common as to property «>f Georges Bernard, and the latter party by these presents personally as well as to authorise his wife by to these presents, of Rimouski, district of Bimouski, are defendants, ordering the licitation «>f the immoveables «lesignated as follows: I.An emplacement situated at L'Abord-à-Plouffe, Levesque Boulevard, forming part of lot No.two «>f the subdivision of the lot No.forty-six (46-P.2) of the official plan and book of reference of the parish of St.Martin; measuring sixty-five feet in width by two hundred feet in depth, English measure and more or less; bounded in front by Levesque Boulevard; on the southwest si«le by lot No.46-1 of the said ca«lastre; in rear and on the north-cast side by other parts of the said lot No.46-2; with the house ami the buildings thereon elected, liearing No.4555 Levesque Boulevard, with the servitudes active ami passive attached thereto; II.Another emplacement situated at L'Abord-à-Plouffe.Levesque Boulevard, and formed as following; 1.Of a strip of Ian«l being part of the lot known and designed under the number forty-eight (part 48) of the official plan ami book of reference of the parish of St.Martin; measuring one hundred and eight feet in width in the front ami one hundred and one feet ami four inches in 1075 \\ ingt -film pieds de profondeur, mesure anglaise el plus ou moins; bornés en front par le boulevard Lèves» pie; du côté nord-est par le lot N° \u2022P.l dudit cadastre; en arrière et du côté sud-ouest pgr d SUtrSS parties dudit lot \\° -18; 2 Kt d'une autre lisière «le terre faisant partie du lot connu et désigné sous le numéro quarante-i:ciif (plie 40) sur le plan et au livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin; mesurant s.i\\ante-(piutorzc pieds de largeur en avant et û- i - dessus construites, 3° Partie «le la moitié nor«l-est «lu lot numéro vingt et un au plan et livre de renvoi «lu cadastre olliciel pour le dixième rang «lu canton «le Ham, de la c«)ntcnanr the tenth range of the township of Ham, containing a quarter «>f an arpent on the width along the front road between ranges nine and ten along a half arpent in depth, bounded in front on the northeast by the public road, on one si«lc on the southwest, by the southwesterly half of lot twenty-one, in «lepth ami on the other side, by the residue of the same lot northeast half twenty-one, with buildings thereon erected, circumstances ami dependencies.To be sold at the parochial church il«h)r of Sts-Martvrs Canadiens, countv of Wolfe, on the SEVENTH day of APRIL.1900.at THREE o'clock in the afternoon.FÉLIX HOULE, Sheriff's Office, Sheriff.Arthahaska.March 1st.1900.53220-10-2 BEAUCE Fieri Facias de Horn's et de Terris District of Beauce Magistrate's Court, ( T3 OGER ROY.trades-to wit: 1 man, domiciled at No.28310.) Lambton, in the district '«)f Beauce, against GÊ- RARI) ROY, heretofore domiciled at Lambton, in the district of BeaUCC, presently of whereabouts unknown, to wit: Lot 8-F a quarter of an arpent in width by an arpent in length, bounded as follows: front, Principal Street, southwest side, lot on church property, southeast side, by Bertram! Belgrade, and on the northeast side, by Mrs.Adolphe Gagnon.To be sold at the parochial church door, in the parish of Lambton, in the countv of Frontenac, on the TWENTY-FIFTH day of MARCH next at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, J.S.POULIOT, St-Joseph de Beauce, Sheriff.February 17, 1900.530SS-X-2 [First insertion: February 20, I960] [Second insertion: March 5, I960] B E AI\" II A RNOIS Fieri Facias île Terris District of Beauharnois Superior Court.(/CENTRAL MORTGAGE No.4209.\\ ^ & HOUSING CORPO-' RATION, a laxly corporate ami politic, duly incorporated according t law, and having its head office in the city of Montreal, plaintiff, vs PAUL EUGENE PICHER, of Chateauguay.district «if Beaubarnois, defendanL 1078 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql ÊBEC, Québec, 6 mars 190O, Tome 92, A'° 10 \"l'n immeuble ayant front sur lu rue Crépin à Chateauguay, comté f the parish of St.Joachim of Chateauguay; 2.Of the- whede- of lot number five' hundred and thirly-f'eiur eif the official subdivision of the original lot numbi r tWO hundred and seventy-eight (278-534) e>f Unofficial cadaster of the parish of St.Joachim of ( 'hâte augiiay : With all the buildings erected thereon, and notably, a I on-e ai el its dependencies, bearing civic number 79 Crépin street, town of Chateauguay, County of Chateauguay.wheise wall is common to the neighboring property.As the- Whole is j n sintly found, with all the active aid passive servitmlcs, apparent r unapparrnt attach* «1 tei said immoveable, with neigher exception nor reservation on the part of the borrower.\" To be sold at the parochial church door of Notre-Dame de l'Asson ption, county of Chfi-t.anguav.on THURSDAY the FOURTEENTH day of APRIL, 1900.at TEN o'clock a.m.ERNEST POIRIER.Sheriff's Office.^ Sheriff.Salabe rrv de Valhyficld, February 29, 1900.53221-10 2 [First publication: March 5, 1900] Fieri Facias de Hon is et de Tern's District de Beaubarnois » (dur Supérieure.J p.\\lL VIAL LIMITÉE, N° 4098.} * corps politique et incor-' poré ayant sein bure au d'affaires dans la cité ele Salabe r y de Yal'cyfie Id district de Beaubarnois, demandeur, contre CYPRIEN DROUIN, de la cité ele Salaberry «le Yalhyfied, district ele Beaubarnois,.défendeur, \"Les lots de terre connus et désignés sous les numéros soixante-quinze et soixante-seise, de la subdivision «lu lot «le terre connu et désigné au plan et «lans le livre «le renvoi officiels de la ville eh> Salaberry «le Yalleyfie lel, sous les numéros (0-75 et 70), contenant les «leux lots quatre-vingt-quinze pieds «le largeur, par quatre-vingt-seize pieds «le profondeur, mesure anglaise, avec une maison et autres bâtisses dessus construites.Pour être vendus \"en bloc\" au Bureau «lu Shérif au Palais de Justice à Valleyfh Id, district de Beaubarnois, le MARDI.DOUZIÈME jour d'AVRIL, 1900, à ONZE heures «le l'avant-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.Salaberry de Yalleyfie lel.1er «le mars 1900.53223-10-2-o [Première publication le 5 mars 1900] Fieri Facias de Terris District de Beaubarnois Cour Supérieure, (pÉRARDT H É O RE T, N° 448G.\\ journaliste, de Salaberry ' de Yalleyfiehl, district de Beaubarnois, demandeur, contre LES HERITIERS DE FEU ALBERT LOISELLE, en son vivant, contracteur, «le la paroisse de St-Thimo-thée, district de Beaubarnois, «léfemleurs, et J.-NESTOR HAMEL, Montréal, district de Montréal, en sa qualité de syndic à la faillite de Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Beauharnois Superior Court, / pAUL VIAU LIMITÉ!',.No.4098.\\ body politic ami incorpo-y rated having its head oflice in the city of Saliberrv de Va lievfù'ld, district of Beaubarnois, plaintiff, vs CYPRIEN DROUIN, of the city of S; liberty de Yallcyfiilel, district of Beaubarnois, défendent, \"The lots of land known and designated under the numbers seve nty-fivc and seventy-six, of the subdivision of tl c lot of land known and designate d in the official plan and book of reference of the town of Srlabe rry ele V; lie yfie lel.under the numbers (0-75 and 7(5), containing the two lots ninety-five feet in width, by ninety-six feet in depth, English measure, with a house and other buildings constructed tl er on.To be sold \"en bloc\" at the Sheriff's Office' in the Palace of Justice at Vallevfiehl.district ol Beau» arnois.TUESDAY, the TWELFTH day «\u2022f APRIL, 1900.at ELEVEN o'clock a.m.ERNEST POIRIER.Shi riffs Office, Sheriff.Sal\"berry «le Vail-vfield, March 1st, 19C0.53223-10-2 [First publication: March 5, 1900] Fieri Facias de Terris District of Beauharnois Superior Court, It \"S É R A R D TIIÊ O R E T.No.4480.\\ >J journalist, of Salaberry l de Vallcvfield, district of Beauharnois, plaintiff, vs THE HEIRS OF THE LATE ALBERT LOISELLE, in his lifetime, contractor, of the parish of St-Thimothée, district of Beauharnois, «lefendants, and J.-NESTOR HAMEL, of Montreal, district of Montreal, in his capacity as trustee in the bankruptcy of the QUEBEC Oil-ICI AI.GAZETTE, Quebec, March 6th, fm, Vol.98, No.tO 1079 la succession «le feu Albert Loiselle, ci-«levant de la paroisse de St-Thimothée, district «le Ih'uu- hainois.niis-eii-cause, et ANTOINE DUPUIS, de Beauharnois, district «le Beauharnois, en sa qualité «le legistrateiiT «le la division d'enregistrement de Beauharnois, mis-en-cause.A savoir: \"«/) he lot numéro dix «le la subdivision officielle «lu lot originaire numéro cin74 ; à l'ouest par 1«\" lot numéro 574-10, ayant une superficie de 1,315 pieds carrés.VveC toutes les bâtisses ci-deSSUS érigées.\" Tour être vendu à la porte «le l'église paroissiale f the subdivision f the official ec District «>f Hull Superior Court, [ J BONHOMME & FUS No.8499.< ¦L'' LTÉE, a legally incor-' poruted corporation and having its heu«l oflice at Maniwaki.district of Hull, plaintiff, vs HUGHES DUVAL, of Maui-waki, «listriet of Hull, «lefemlant.\"A certain parcel of laml of irregular f< forming part of lot 2-1.range A, township of Egan, t«)wn «if Maniwaki, county of Gatineau, Province of Quebec, which part of land ina\\ * more particularly described as follows: Starting ut a point situated at a «listance of one hundred feet (100') south of the southwest corner of lot 1-32 of the official cadaster of the township of Egan, lot 1, range A; thence, southerly direction for a distance of sixty i el (00') thence, turning a right angle on the east for a distance of one hundred (100') feet; thence, turning a right angle on the north at a distance of sixty (00') feet; thence, turning a right angle on the west for a «listance of one hundred (100*) feet to the starting point.The sai«l parcel of land thus «lescribed contains in area six thousand s«piare feet (0.000 sp.feet) ami is bounded on the north by a part of lot 2-1 property of Ahlège Beaulieu, on the east, by a part of lot 2-1 property of Ahlège Beaulieu.on the south, by a part of lot 2-1 property of Aldège Beaulieu, ami on the west, by a part «)f lot 2-1 (projected street) property of Ernest Nault, with buildings thereon erected, circunista i -and dependencies\".To be sold at the church door of PAssompt on, in the town of Maniwaki, on the FIFTEEN I'll day of MARCH next, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST-PIERRE.Sheriff's Office, Sherifl Hull, this 0th day of February, 1900.53020-7-2 Cumula \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, ( JEAN BRABANT.black-No, 0890.\\ J smith.«>f Limbour.dis-' trict of Hull, plaint ill.va GEORGES MOREAU, jr.«»f Limbour, district of Hull, defendant.\"An immoveable known ami designated ss follows: Part «»f hit number seven \"A\" \\) range eight (8), towhship of Hull, measuring sixty (GO) feet in width along the public road by about two hundred (200) feet in depth, ss bounded by a deed of sale dated July II.195(i.pa ied .before Me F.A.Binet, consented to by Georges Moreau, Sr., to Georges Moreau, Jr., ami duly registered; with the buildings thereon erected, circumstances ami dependencies.To be sold at the church door of St-Alexandre.at Limbour.said «listriet.on the EIGHTH «lay QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Mord, r,th, mm.Vol.>.u.So.10 1081 lu mois d'AVRIL I960, DEUX heure» de l'après-midi.Le Shérif.liureau du Shérif, K.ST-PIERRE.Hull, ce 1er mars i960.53220 I0 2 Canada Province de Québec District «le Hull ( Miirdr Magistrat .i AIM K LAROSE, élec-N° 8295.j a* tricien, faisant affai-' r< s à ( iatimau, sous le nom La rose Electric, demandeur, va HENRI DAGENAIS, Cantley, P.Q., défendeur.'Tu immeuble connu el désigné connue étant rtie du l«>t 8-B, rang 10, canton «le Hull, luesuranl 126 pieds «le largeur par 150 pieds de i rofondeur, plus ou moins, borné au nord par partie «In même lot, propriété d'un nommé Dick Itafter ou représentante, au sud par partie «lu même l«it.propriété de Madame Simone Moreau représentants, à l'est par partie «lu même l«it.propriété de Delphis Whisselle ou représentants, i à l'ouest par le chemin f Quebec District of Hull Magistrate's Court, / AIMÉ LAROSE, else-No.X295.\\ *a trician, carrying on ' business at Gatineau under the name «>f Larose Electric, plaintiff, vs HENRI DAGENAIS, < antl.y.P.Q., defendant.\"An immoveable known and designated being part «>f lot 8-B, range 10, toa nsl ip of Hull, measuring 125 f«ct in width by 150 feet in tlcptii, more or less, hounded on the North by part °f the sane lot.prop« rly of one ran « «I Dick Rafter «ir representatives, on tl the public road at St-Emile («les Érables Street), with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To he sold at the parochial church door of St-Emile, countv of Quebec, on the EIGHTEENTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the forenoon.Dr.J.R.GOBEIL, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, February 9, 1900.53027-7-2 (First insertion: February 13, 1900] (Second insertion: March 5, 1900] Fieri Facias Quebec, to wit :j JACQUES LABRECQUE, No.86,330.\\J general contractor, dom-cile«l at 5 Lehrecque Street.Orsainville.«listriet «if Quebec, P.Q., against Dame J.B.L.LAJEUNESSE, wife of J.ft L.La jeunesse, residing at 470 Ste-Agncs Street.Quebec, «listriet of Quebec.P.Q.Notice is hereby given that the immoveable that was t«) have been sold in the present CSSS at the parochial church door of Charlesbourg, countv of Quebec, on the TWENTY-SIXTH day of FEBRUARY at TEN o'clock in the morning, ami which was not.shall be sold at the same place on the ELEVENTH day of MARCH, 1900, at TEN o'clock in the forenoon.Dr.1.R.GOBEIL, Sheriffs Oflice.Sheriff.Quebec.February 20.1900.53200 (First insertion: March 5, I960.] RIMOUSKI Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski and Saguenay Superior Court, I DENOl T PELLETIER, No.21,295.-\\ Lj tradesman of the town ' of Matane.«listriet of Rimous- ids » GAZETTE ol I ICI ELLE DE Ql ÊBEC, Quebec, ô mars 1960, Tome 99, N 10 demandeur; vl REAL BERNIER, de la ville de Sept-Iles, «listriet «le Saguenay, défen-« leur.Le lot portant le numéro trois eenl cinquante- cinq (355), rang 2, du canton Letellier, situé en lu ville «le Sept-Iles, avec bàtisiCl «Icssiis eolis-truites.circonstances et «h'-pcudauccs.Le lot portant le numéro quatre cent soixante-«piatre (464), rang 2.«lu camion Letellier, situé dans la vill«- «le Sept-Iles, sans bâtisse.Pour être vendus en bloc, à la porte de l'église catlioliipie «le la paroisse «le St-Joseph, ville de Sept-Iles, le SEIZIEME jour de MARS, I960, à DEI X heures «le l'après-midi, (heure de l'Atlantique) Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, JACQUES MARTIN.Rimouski, B février 1900.53017-7-2-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province «le Québec District de Rimouski «-t Saguenay Cour Supérieure.(DOCO INCORPOR Ê.N° 22,396.\\ *^ corps politique légale- \\ ment constitué ayant une place d'affaires en la ville cputv-Sheriff.Rimouski, February 8, I960.63017-7 2 Fieri Fadas de Ferris Canada - Province of Quebec District of Rimouski and Sagia nay Superior Court, i T) OCO INCOR FOR i No.22,396.( a% a body politic leg ' incorporated having a pi.«if business in the town of Sept-Hes.district Saguenay.plaintiff, vs JEAN-MARIE BAH BONI, living and residing in the town of Sej Iles, «listriet «>f Saguenay.1.A lot of land known and designated undei number part of thirty-five-two-A (1*.35-2.\\ range one (1) according to the official plan .I .in tin- book of reference of the cadaster for I village of Sept-Iles, situated in the town of Si pt- Des, Letellier township, five feet (5) wide by oi i hundred (100) feet in depth, and bounded as fol lows: northwest.thirty-fivc-one-B-onc (35-1-B-l i, northeast, Brochu Avenue, south* ast.residue of lot thirty-five-2-A (36-2-A), ami on the southwest thirty-hve-onc-B-two (35-1-B-2), with buildil ga 2.A lot of land known and designated undei number part of thirty-fivv-B-one (P.35-1-B-l of range one (1).according to the official plan and book of reference of the cadaster for the village of Sept-Ih s.situated in the town of Si Iles, Letellier township, measuring fifty (50) fc< I in width and one hundred (KM)) feet in length and bounded as billows: northwest lot thirty-five-one-A-onc (35-1-A-l), northeast, Brochu Avenue, southeast.thirty-fiv«-two-A (36-2-A) and thirty five-two-B (35-2-B) ami on the southwest thirty tive-one-B-two (35-1-B-2).With buildings.3.A lot of land known and designated undi number part of thirty-flve-one-B-two (P.35-1 -1 ' 2).of range one (1) according to the official pli ' and in the book of reference «>f the eadasli r fi the village «)f Sept-IIes.situated in the t«iwn ol S«'pt-Iles.L«'tcllicr township, measuring fift.v (50) feet in width and one hundred and twenty-five (125) feet in length and bounded as follows: northwest by lots thirty-fivc-one-A-two (35-1-A 2).and northeast, lot thirty-five -one (35-1-B-l southeast thirty-five-B-two (35-B-2) and southwest, l«>l thirty-five onc-B-two (35 l-B-2).With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To bn de Chatham comme formant partie du l«>t numéro huit cent quinze (Ptie 815) mesurant cent vingt-six pieds (120') plus ou moins de l'est à l'ouest et eimpiantc pieds ('.0') «lu nord au sud; borné au nord par partie du même l«-t appartenant à monsieur Séguin, à l'est par la prolongation vers le nord de la rue Rank, au sud par remplacement «-i-après décrit au troisième paragraphe et à l'ouest par partie duThtéme lot appartenant à M.Martin.Avec bâtisses.\u20221° Un certain emplacement situé sur le côté non! de la rue Principale dans le village «le brownsburg connu et désigné aux plan et livre \u2022 renvoi officiels «lu canton «le Chatham connue ¦ormant partie du lot numér») trois «le la subdivision officielle «lu lot originaire numéro huit cent seize (Ptie 816-.'!) mesurant trente-sept Canada Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court.(T AURENTIDE EN TE It-No.30457.< A-* PRISES INC., body lc-v gaily constituted, having its head oflice in the city of St-Jérôme, «listriet of Terrebonne, plaintiff, vs GAETAN LA FOREST, luitcl-kceper of Brownsburg, «listriet of Terrebonne, denfendant.Notice of sale The immoveables hereinafter designated in the possession f the defendant; 1.A certain emplacement situated on the north side of Principal street in the Village «>f Brownsburg.known ami designated in the official plan and book of reference «J the township of Chatham as binning part of lot number eight hundred and fifteen (P.815) having a frontage «»f one hundred feet on the saitl street and one hundred seventy-five feet feet in depth (100* x 175') bounded on the south by the said street, on the west by the property of Mrs.Stewart or of her representatives, f reference of the township «>f Chatham as forming part of lot number eight hundred and fifteen (P.815) measuring one hundred ami twenty-six feet (120'), more or less, from east t«) west ami fifty feet (ô(V) from north to south; bounded on the north by a part of the same lot belonging to Mr.Séguin, on the east by the prolongation towards the north of Bank street.OU the south by the emplacement hereinafter described in the third paragraph ami on the west by part «>f the same lot belonging to Mr.Martin.With buildings.3.A certain emplacement situated on the north side of Principal street in the village of Brownsburg known and designated in the official plan and book of reference of the township of Chatham as binning part of lot number three of the oflicial subdivision of the original lot number eight hundred and sixteen (P.816-3) 1088 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 6 mars (960, Tom, 99, A 10 pieds (37') «le largeur sur une profondeur d'environ cent soixante-dix-neuf pieds (I79'); borné au nord par l'emplacement ci-devant décrit au deuxième paragraphe, à Petit par la prolongation de la rue Hank, au siul par la me Principale et à I ouest par I emplacement ci-devant décrit au paragraphe premier.Avec bâtisses.Pour être vendus \"en bloc\" à la porte de l'église catholique de Brownsl urg MERCREDI le SIXIÈME jour d'AVRIL 1060a DEUX heures «le l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.GEO.AUCLAIR.St-Jérôme, '-'«t février I960.63213-10-2-O measuring thirty-s«-\\«-n feet (37') in width l»\\ a depth f about one hundred and seventy-nine feet (179'); bounded on the north by the emp .ment pr«-\\ ioiisly described in the second pa graph, on the cast by the prolongation f Bank st reet, on the sont h by Principal st reel and on 11 e west by the emplacement previously described in the first paragraph.With buildings.To be sold \"en bloc\" at the door of the Cat lie church of lirownshiirg on WEDNESDAY the SIXTEENTH day of APRIL, I960 it TWO o'clock p.m.GEO.AUCLAIR, Sheriffs Office, Sheriff.St-Jérôme, February 29th, I960.53213 H J Canada Province i-triit de I rii bonne \u2022Cour Supérieure, l T 'OFFICE DU CREDIT X° 30386.j *\u2022* AGRICOLE DU QUE-' BEC, corps p« litique et incorporé avant son siège social à Québec, requérant, vs EJJGÊNE PAQUETTE, cultivateur, domicilié à Arundel comté d'Argenteuil, P.Q., intimé.Avis de vente Lis immeubles suivants; a) \\v lot «le terre numéro dix-huit A (18a) c.requérant vs ROGER TASSÉ, cultivateur domicilié à St-.lovitc.co tit*'- «le Terrebonne, P.Q., défendeur: Avis «le vente [a's lots «le terre numéros «lix-sept et vingt (17 et 20) «les f> 1 ;n et livre de r.nvoi officiels «lu canton DcS:iliherry.avec maison et dépendances y érig< ni e, THURSDAY, the SEVENTH day of APRIL, 1060, at ELEVEN o'clock in the fir.no* n.GEO.AUCLAIR, Sheriff's Office, Sheriff.St-Jérôme, February 29.I960.53216-10-2 index de la Gazette officielle de Québec, N° 10 \\' tions en separation i)e uiens: Harrisson vs Montagne.1045 Pelchat vs Forgues.1045 Avis aux intéressés: 1029 \\\\is divers: Melleterre Quebec Mines, Limited (Dist.de l'actif).104S Capital Developments Inc.(Directeurs) 1045 ha Clinique de Rehabilitation pour Knfants Handicapés Inc.(Directeurs) 1047 L'Association «les Employés «le Transport de Ville St-Pierre (Formation).1045 Mansions Radio Limited (Directeurs) .1047 Montreal Chapter, The National Secretaries Association (International) (Directeurs).1040 Kedbrooke Estates Ltd.(Directeurs).1047 Sales Sites Corporation (Directeurs).1040 St.Lawrence Warehouse Inc.(Directeurs) .1047 I 11a utes \u2014 A han dom l)e : Beausejour ft Connolly Construction Inc.1049 Belleterre Quebec Mines, Limited.1049 Unmet Groceteria Ltée.1049 Harmony Enterprises Ltd.1048 Household Sundry Specialties Co.Lie.1049 Pride O'Olen Knitting Mills of Canada Limited.1048 Quebec Ammonia & Gas Exploration Limited.1049 :'mpa«ime autorisée à faire des affaires: Genefax Limited.1050 Index of the Quebec Official Gazette, No.10 Actions fob separation as to Property: Harrisson vs Montagne.1045 Pelchat vs Forgues.1045 Notice to Interested Parties: 1029 Miscellaneous Notices: Belleterre Quebec Mines.Limited (Dist.of assets).1048 Capital*Developments Inc.(Directors).1045 La Clinique «le Réhabilitation pour Enfants Handicapés Inc.(Directors).1047 L'Association «les Employés «le Transport de Ville St-Pierre (Formation).1045 Mansions Radio Limited (Directors).1047 Montreal Chapter.The National Secretaries Association (International) (Directors).104G Redbrooke Estates Ltd.(Directors) .1047 Sales Sites Corporation (Directors).1010 St.Lawrence Warehouse Inc.(Directors).1047 Charters \u2014 Surrender ok: Realise jour & Connolly Construction Inc.1049 Belleterre Quebec Mines.Limited.1049 Brunet Groceteria Ltée.1049 Harmony Enterprises Ltd.1048 Household Sundry Specialties Co.Inc.1049 Pride O'Glen Knitting Mills «>f Canada Limited.104S Quebec Ammonia & (Wis Exploration Limited.1049 Company Licensed to do Business: Genefax Limited.1050 1090 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 mars I960, Tome 92, N° 10 ( 'omi'aii.mks disboutes : Air Tacker Co.Inc.1064 Automation Products Inc.1051 City House Furniture Inc.1051 Karl F.O'Mara & Company Limited 1064 Hutchison Grocery & Provisions Ltd.1062 International Electric Rouyn Limited, 1063 .1.A.Goaselin Sales Ltd.1052 La ( ompagnie de Téléphone d'Yamaska Limitée.1003 La Petite Symphonie de Montréal \u2014 The Little Symphony of Montréal.1053 La Salle Textiles Inc.1053 L'Association des Chevaliers de («ati- neau.Limitée.».1055 Lido Development Corp.1052 Manor Construction Ltd.1050 N.& A.Fihn & Amusement Corporation.1050 Petit Textiles Limited.1051 Plage Ste-Rose Limitée.1055 Stanley Enterprises Inc.1054 Sterling Lands Limited .1055 Sterling Shirt & Overall Limited.1055 St.Lawrence Vinegar Company.1051 cukatellk publique: Egan, Thomas, succession.1050 DÉPA RTE MI ATS \u2014 AVIS DES : Instruction publique: Municipalité scolaire de: Barford.1000 Chicoutimi, paroisse.1056 Jacques-Cartier, cité.1057 St-Christophe-d'Arthabaska.1050 St-Jean-Port-Joli.1000 St-Pierre-4 le-l'Étang.1059 Val Senneville.1057 Terres et Fouets: Service du Cadastre: Ste-Geneviéve.paroisse.1000 St-Eustache, paroisse.1001 St-Laurcnt.paroisse.1001 Stoke, canton.1001 Travail: Industrie OU métiers de: Plombiers, région de Trois-Rivières (Modification).1001 Services funéraires, Ile de Montréal et un rayon de 10 nulles (Modification).1003 Lettres patentes: Agences d'Assurance R.Dupuis Inc.1030 Aima Air Service Lbl.1031 Edmar Sportswear Contractors Ltd.1031 J.E.Poitras Inc.1031 J.Léon Leveaque Inc.1032 J.René Hébert Ltée.1032 Lague Express Inc.1032 Les Entreprises Lux Inc.1033 Les Placements Collin Ltée \u2014 Collin Investment Ltd.1033 Les Produits Chimiques Empire Inc.1033 L'Oeuvre des Terrains de Jeux des Trois-Pistoles.1034 ( omi'ames Dissolved: Air Tacher < o.Inc.lu;, i Automation Products Inc.|().\">| City House Furniture Inc.K).*,! Karl F.O'Mara & Company Limited.1064 Hutchison Grocery & Provisions Ltd.1052 International Klectric Rouyn Limited, 10\" I J.A.Gosselin Sales Ltd.'.1062 La < Compagnie de Téléphone d'Yamaska' Limitée .1053 The Little Symphony of Montreal La Petite Symphonie «le Montréal.1053 La Salle Textiles Inc.10S ; L'Association des Chevaliers de Gati- ueau.Limitée.(055 Lido Development Corp.1052 Manor Construction Ltd.1050 X.& A.Fihn & Amusement Corporation.1050 Petit Textiles Limited.1051 Plage Ste-Rose Limitée.1055 Stanley Enterprises Inc.1054 Sterling Lands Limited.1055 Sterling Shirt & Overall Limited.1055 St.Lawrence Vinegar Company.1051 Public ( !ubatorbhip: Egan.Thomas.Estate.1056 DEPARTMENTAL NOTICES: Education: Se/mot Municipality of: Rarford.1060 Chicoutimi, parish.1056 Jacques-Cartier, city.1057 St-Christ ophe-d'Artàbaska.105 St-Jean-Port-Joli.1060 St-Pierre-de-l'Êtang.1059 Val Senneville.1057 Lands and Forbst: Cadastral Branch: Ste-Geneviéve, parish.1060 St-Eustache, parish.1061 St-Laurent, parish.1061 Stoke.township.100! Labour: Industry or Trades of: Plumbing, region of Trois-Rivières (Amendment).1001 Undertakers' employees, Island of Montreal and a radius of 10 miles (Amendment).1003 Letters Patent: Agences d'Assurance R.Dupuis Inc.1030 Alma Air Service Ltd.1031 Edmar Sportswear Contractors Ltd.1031 J.E.Poitras Inc.103! J.Léon levesque Inc.1032 J.René Hébert Ltée.1032 Lague Express Inc.i.1032 Les Entreprises Lux Inc.10.33 Collin Investment Ltd.\u2014 Les Placements Collin Ltée.1033 Les Produits Chimiques Empire Inc.1033 L'Oeuvre des Terrains de Jeux «les Trois-Pistoles.1034 QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec Starch r.th, mon.Vol.uj, \\.10 1091 L'OcilVrc del Vexations Sacerdotales «lu Diocèse de Mont-Laurier.1034 Lucien Lafrance lue.1034 Maid-RitC Dress Inc.1035 Mattagami Service Inc.1035 Maurice Iléroux Automobile Limitée.1035 Meubla Lagacé Ltée Lagacé Pur- niturc Ltd.1030 Minerals & Chemical (1980) Loi.1030 \\iiiimont Investment Corp.1030 Onit Building Supply Ltd .1037 Overseas Motors inc.1037 I'ettigivw Manufacturing Inc.1037 P\u201euliot Auto Ltée.103S Professional Investment Associates, Inc.1038 Purity Water Products Ltd.- Les Produits AqueUS Purity Ltée.1088 Quebec Reinforcing Steel Inc.1039 Rapids Shopping (entre Inc.1039 Kellim Uniform Co.Ltd.1039 lb nodiffusion Inc.1010 Richelieu Milk Tankers Inc.1040 Roscmount Gas -\\ < Ml Inc.10-10 Saguenay Salvage Ltd.\u2014 Saguenay Récupération Ltée.1041 St-Aubin Automobiles Ltée.1041 Samcy Investments Corp.1041 Sains Sportswear Ltd.1042 Security Hardware Company.1042 S.E.Desmarais & Cie Ltée.1042 Service «les L«>isirs St-Pie X, «le St-Martin .1043 Solid Builders Ltd.1013 Talion & Bonepace Ltd.1043 Trapeze Slmcs Corp.1044 Walnut Products Corporation.1044 Willroth Investment Co.Ltd.1044 Ministère MB Finances: I siirmices: Mercantile Trust Company.1004 Security Insurance Company of New Haven.\u2022.1004 Sii.iiks sociaux: Mcgsntic Knitting Limited.1005 Quebec Pop Corn Inc.1000 Serap & Surplus Ltd.1005 I nited Cutting Dies Ltd.1005 William Paterson & Company Inc.10ti0 Soi missions: beaconsfield, ville.1000) Joliette, ville, comm.scolaire.1008 Longueuil, cité.1000 St-Cvrillc-de-Wen
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.