Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 21 (no 3)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1961-01-21, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 93, \\° 3 293 Vol.93, No.3 I Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Mag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 21 janvier 19GI AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements i ' Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.23 Fournir le texte de l'annonce dans les deux langue! officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.1° Payer comptant et avant publication le coût, des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, January 21st, 1961 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When same is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbclow set forth.Exception being made when the said advertisingcopy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 294 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 98, N\" 8 7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le mer-credi à condition que ce jour de lu semaine^ ne soit pas un jour férié.Dans un tel cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'nrgent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur île la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agale, i>our chaque version, (14 lignes au pouce, soit 2G6 lignes par page, pour les deux versions).Insertions Subséquentes! 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont lu signification suivante: Le premier chiffre réfère à noire numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o )) signifie que la matière n'est ni de notre composition ni rie notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Heine, Rocu Lefebvre.Hôtel «lu Gouvernement, Québec, 5 décembre 1900.53551 \u2014 l-53-o Lettres patentes (P.G.15053-60) Association .Métropolitaine des Calés et Restaurants Licenciés (Metropolitan Association of Licensed Cafés and Restaurants) Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1960, constituant en corporation sans capital-actions: Ralph Cobetto, gérant de cabaret, Roland Paul, agent, tous deux de Montréal, et Jacques Florent, comptable, de Verdun, pour les objets suivants: Grouper en association les personnes qui exercent le commerce de cabarets, de cafés, de restaurants, de clubs et de grills; étudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses membres, sous le nom de « Association Métropolitaine «les Cafés et Restaurants Liecn- 7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Wed* nenday, providing that this day of the week is not a holiday.In such case, the ultimate «lelay expires at noon on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is en-titled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.\"Single copies: 30 cents each.Slips: SI per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third to the number of insertions, and the letter ' o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.Boca Lefebvkf., Queen s Printer.Parliament Buildings, Quebec, December 5th, I960.53551 \u2014 1-53-0 Letters Patent (A.G.15053-00) Association Métropolitaine «les Cafés «\u2022! Restaurait Is Lieenciés (Metropolitan Association of Licensed Calés and Restaurants) Notice is hereby given that under Part III ot the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of t lie Province of Quebec, bearing date the first day of December, I960.tt> incorporate as a corporation without share capital: Ralph Cobetto, cabaret manager, Kola ml Paul, agent, both of Moid real, and Jacques Florent, accountant, of Verdun, tor the following purposes: To group into an associât ion the persons carrying on the business of cabarets, cafés, restaurants, clubs and grills; to study, promote, protect and develop in ull manners the economic, social and professional interests of its members, under the name of \"Association Métropolitaine «les Cafés et Restaurants Licenciés \u2014 (Metropolitan QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January Hint, 1961, Vol.98, Xo.3 295 , ii's \u2014 (Metropolitan Association of Licensed ( a tVs and Restaurants) ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est «le 150,000.Le siège social de la corporal ion sera à Mont-réal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le premier décembre 1900.L'Annuitant-procureur général adjoint, 50288-0 P.Fkenette.(P.G.15149-60) Baruchson Holding Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a clé accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres putentes, en date du cinq décembre 1900, constituant en corporation: Samuel ('hait, Nathaniel H.Salomon, tous deux de Montréal, Harry Aronovitch, de Côte-St-Luc, tous trois avocats, et John Hamilton fils, secrétaire, «le Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de placements, cl de portefeuille, sous le nom de « Baruchson Holding Corporation », avec un capital total de 139,10$ divisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur uu pair de SI0 chacune, 100 actions privilégiées, catégorie « A », «l'une valeur uu pair de SI chacune et 880 actions privilégiées, catégorie « B ».«l'une valeur au pair de $100 chacune.If $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth «lay of October.1900.' P.Frenette.50288-o /Issistant Deputy Attorney General.(P.G.13992-60) Federal Roofing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en «late du vingt-cinq novembre 1960, constituant en corporation: Benjamin Rappaport, chimiste pharmacien, Hyman Stoller, ingénieur civil, et Maurice Ojalvo.administrateur, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, constructeurs, couvreurs, acheteurs de débris, démolisseurs, et comme fabricants d'acier d'armature et d'acier renforcé et exercer le commerce d'ouvriers du métal et de la pierre, fondeurs et mécaniciens et exiVuter tels autres travaux qui peuvent être requis dans le commerce de la construction, sous le nom de « Federal Roofing Co.Ltd.», avec un capital total de $30,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 284 Chemin Chambly, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général; le vingt-cinq novembre 19(50.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288 P.Frenette.(P.G.14935-GO) G.Ross Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par lé lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze novembre 1960, constituant en corporation: Isidore Ross, entrepreneur, Hu-guette Ross, marchande publique, fille majeure, et Anita Ross, ménagère, épouse de Ghislain Ross, et dûment autorisée et assistée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs, entrepreneurs et sous-eut repreneurs, sous le nom de « G.Ross Construction Co.Ltd.», avec un capi- (A.G.13992-60) Federal Roofing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of November, 1960, incorporating: Benjamin Rappaport, pharmacy chemist, flyman Stoller, civil engineer, and Maurice Ojalvo, executive, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractns, builders, roofers, wreckers, demolishes and as fabricators of structural steel and reinforcing steel and to carry on business as metal workers, stone workers and foundry men and machinists and to do such other work as may be useful in the construction and building business, under the name of \"Fetleral Roofing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 3,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 284 Chemin Chambly, Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November, 1960.P.Frenette, 56288-0 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.14935-60) G.Ross Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of November, 1960, incorporating: Isidore Ross, contractor, Huguette Ross, marchande publique, spinster of the full age of majority, and Anita Ross, housewife, wife of Ghislain Ross, and duly authorized and assister by him for the purpose of these presents, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders, contractors and sub-contractors, under the name of \"G.Ross Construction Co.Ltd.\", with a total capital QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1!)61, Vol.03, So.3 299 tal total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées du $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2663 est, rue St-Zotique, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1960.L'AssistatU-procurcur général adjoint, 56288 P.Frenette.stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will he at 2663 Saint-Zotique Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November, 1960.P.Frenette, 56288-0 Assistant Deputy Attorney General.(P.G.14867-60) Henry Ticker Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a .\u2022Lé accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres putentes, en date du dix novembre 1960, constituant en corpora-tion: Michael Garber, de Westmount, Jacob Harold Blumenstein, de Montréal, tous deux avocats et conseils en loi de la Reine, et Harry Yohalcm Garl>er, avocat, «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de nettoyeurs, presseurs, teinturiers, buandiers et raccomodeurs de vêtements, tissus, marchandises et fournitures de maison, sous le nom de « Henry Ticker Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 1.0(H) actions ordinaires de $10 chacune et 3.000 actions privilégiées de $10 chacune.te siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1960.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288 P.Fhenette.(A.G.14867-60) Henry Ticker Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1960, incorporating: Michael Garber, of Westmount, Jacob Harold Blumenstein, of Montreal, both advocates ami Queen's Counsels, and Harry Yohulem Garber, advocate, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of cleaners, pressera, dyers, launderers and repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings, under the name of \"Henrv Ticker Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November, 1960.P.Frenette, 56288-o Assistant Deputy Attorney General.(P.G.15050-60) Kwik Park Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq novembre 1960, constituant en corporation: Manuel Shacter, de Dur val.Leo Rosentzveig et William Levitt, ces deux derniers de Montréal, tous avocats, pour les objets' suivants : Garder, entretenir, exploiter et gérer des terrains de stationnement, garages, magasins, salles d'emmagasinage, entrepots et autres endroits semblables, pour le bon entretien, le nettoyage, la réparation et le soin général des automobiles et véhicules moteurs, sous le nom de « Kwik Park Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq novembre 1960.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288 P.Frenette.(A.G.15050-60) Kwik Park Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of November, 1960, incorporating: Manuel Shorter, of Dorval, Leo Rosentzveig and William Levitt, the latter two of Montreal, all advocates, for the following purposes: To keep, maintain, operate and manage parking lots, garages, storehouses, storerooms, warehouses and other like places, for the safekeeping, cleaning, repairing and care generally of automobiles and motor cars, under the name of \"Kwik Park Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 36.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November, 1960.P.Frenette, 56288-o Assistant Deputy Attorney General.(P.G.14763-60) L'Agence Publicitaire Beau-Mont Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept novembre 1960, constituant en corporation: George Bey, Michael Awada, avocats, et (A.G.14763-60) L'Agence Publicitaire Beau-Mont Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of November, 1960, incorporating: George Bey, Michael Awada, advocates, and^Peter 300 GAZETTE OFFICIELLE DE QUE H EC, 21 janvier 1961, Tome 93, .Y° 3 Peter Millier, étudiant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de propriétaires de journaux, imprimeurs généraux, éditeurs, papetiers, lithographes, graveurs, relieurs libraires et fondeurs de caractères, sous le nom de « L'Agence Publicitaire Beau-Mont Inc.», avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compugnic sera à Beloeil, district judiciaire de liiehelicu.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1900.L'Assistant-procureur général adjoint, 502SK P.Frenette.(P.G.13534-00) Les Productions Baladin.& Cic Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept août 1900, constituant en corporation: Mario Du Mesnil.avocat, Denise Sauva-geau et Hélène Lampron, ces deux dernières secrétaires, filles majeures usant de leurs droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de producteurs et d'éditeurs de projections animées, et exploiter des ateliers de projections animées, sous le nom de « Les Productions Paladin & Cic Liée », avec un capital total de $49,GC0, divisé en 900 actions communes de $10 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept août 1960.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-o P.Frenette.Milner, student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of newspaper proprie tors, general printers, publishers, stationers, lithographers, engravers, book binders, book sellers and type founders, under the name of \"L'Agent e Publicitaire Beau-Mont Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be Ql Beloeil, judicial district of Richelieu.Duted at the office of the Attorney Goner.- ' this seventh day of November, 1960.P.Fkenette, 58283m Assistant Deputy Attorney General.(A.G.13534-60) lies Productions Baladin & Cie Lté* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the seventeenth day of August, 1960, incorporating: Mario Du Mesnil, lawyer, Denise Sauvageau and Hélèm Lampron, the latter two secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes To carry on the business of motion picture producers and editors, and to operate motion picture studios, under the name of \"Les Prodne tions Baladin & Cie Ltée\", with a total capital stock of $49,000, divided into 900 common shares of $10 each and 400 preferred shares of $100 each The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Generul.this seventeenth day of August, 1960.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(P.G.15095-60) Les Produits d'Orléans Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1960, constituant en corporation: Louis-Philippe Dallaire, commis-voyageur, de Ste-Foy, Jules Baillargeon, notaire, et Mlle Cécile Huard, secrétaire, ces deux derniers de Québec, pour les objets suivants: Commerce de produits alimentaires, sous le nom de « Les Produits d'Orléans Inc.», avec un capital total de $60,000, divisé en 60 actions communes de $100 chacune et en 540 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 69, rue Pierre Maufay, Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1960.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-o P.Frenette.(A.G.15095-60) Les Produits d'Orléans Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-third day of November, 1960, incorporating: Louis-Philippe Dallaire, travelling-salesman, of Ste-Foy, Jules Baillargeon, notary, and Miss Cécile Huard, secretary, the latter two of Quebec, for the following purposes: To «leal in fo«xl products, under the name of \"Les Produits d'Orléans Inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 60 common shares of $100 each and 540 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 69, Pierre Maufay street, Ste-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the .office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1960.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(P.G.14854-60) Maison Charles Dresseteria Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seise novembre 1960, constituant en corporation: Kalman Samuels, avocat, Stella Samuels, (A.G.14854-60) Maison Charles Dresseteria Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1960, incorporating: Kalman Samuels, advocate, Stella Samuels, housewife, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1961, Vol.93, No* 3 301 ménagère, épouse séparée tie l.icns dudit Kalnian Sauniers, du barreau de lu Colombie Britannique, et Gillian Scrasc, secrétaire, fille majeure, tous le Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de robes pour dûmes et tous .litres articles vestimentaires pour dames, squs le nom de « Maison Charles Dressetcria Ltd.», avec un capital total de $20.000.\" divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compugnic sera à suite 308, 1434 ouest, rue Ste-Cntherine.Montréal, listrict judiciaire de Montréul.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1960.L'Assistant-pwureur général adjoint, ÏG288 P.Frenette.P.O.15084-60) Placements Nolin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première ; irtie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date 'lu vingt-deux novembre 1960, constituant en corporation: Roger Létourneau, Pierre La Hue, avocats, et Thérèse des Rivières, secrétaire, fille : Majeure, tous de Québec, pour les objets sui-'.uits: Agir comme compagnie de placements per-:mcls, sous le nom de «Placements Nolin inc.», avec un capital total de $100,000, divisé ¦a 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 9,500 actions privilégiées 'l'une valeur.au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 131, \u2022 ième rue, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux novembre 1960.//Assistant-procureur général adjoint, 56288-0 P.Frenettk.P.G.13633-60) René Chartrand Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1960, constituant en corporation: René Chartrand, industriel, de la ville Anjou, Guy Chartrand, industriel, et Marie-Anna Brouillette Chartrand, ménagère, veuve \u2022l'Achille Chartrand, ces deux derniers de Terrebonne, pour les objets suivants: Commerce de meubles, nouveautés, bois et in très matériaux et produits, sous le nom de « René Chartrand Ltée », avec un capital divisé en 200 actions sans valeur au pair ou nominale et en 120 actions privilégiées de $100 chacune, < t le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $3,000.Le siège social de la compagnie sera à Terre-'\u2022onne, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1960.L'Assistant-procureur général adjoint, \")0288-o P.Frenette.(P.G.14011-60) Roger Chouinard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a wife separate as to property of the said Kalman Samuels, of the Bar of British Columbia, and Gillian Berate, secretary! spinster, all of Montreal, for the following purposes ! To deal in women's dresses and all other women's apparel, under the name of \"Maison Charles Dresseteria Ltd.\", with a total capital stock of $20,060.divided into 100 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the companv will be at Suite 308, 1434 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November.1960.P.Frenette, 56288-0 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.15084-60) Placements Nolin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1960, incorporating: Roger Létourneau, Pierre LaRuc, lawyers, and Thérèse des Rivières, secretary, fille majeure, all of Quebec, for the following purposes: To act as a personal investments company, under the name of \"Placements Nolin Inc.\"-, with a total capital stock cf $100,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 9,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 131, 7th Street, Quebec, judicial district of Queliec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1960.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.13633-60) René Chartrand Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1960, incorporating: René Chartrand, industrialist, of the town of Anjou, Guy Chartrand, industrialist, and Marie-Anna Brouillette Chartrand, housewife, widow of Achille Chartrand, these last two of Terrebonne, for the following purposes: To deal in furniture, novelties, wood and other materials and products, under the name of \"René Chartrand Ltée\", with a capital stock divided into 200 shares without nominal or par value and 120 preferred shares of $100 each, and the amount with which the company will start its operations will be $3,000.The head office of the company will be at Terrebonne, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November, 1960.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.14011-60) Roger Chouinard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent have 302 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier /.%'/.Tome .93.V° 3 été accordé pur le lieutenunt-gouvcrneur de la province tie Québec des lettres patentes, en date du neuf novembre 1900.constituant en corporation: Roger Chouinard.Jean-Guy Chouinard, entrepreneurs en planclier, et Jeannette Holliu Chou n lard, ménagère, épouse contract uelleinent séparée tic biens dudit Roger Chouinard, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de LaSalle, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs en construction «le parquets, sous le nom de « Roger Chouinard Inc.».avec un capital total tie $40,000, divisé en 400 actions «le SI00 chacune.Ia?siège social de la compagnie sera à LaSalle, district jmiieiaire de Montréul.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le neuf novembre 1900.L'Assistant-procureur général adjoint.56288-0 P.Frenette.(P.G.14071-00) K.S.Ka-tman Ltd.Avis est donné qu'en vertu tic lu première partie de lu Loi «les compagnies tie Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur tie lu province de Québec des lettres patente-, en date du quinze novembre 1900.constituant en corporation: William Maxwell Ford, avocat, tie Bon-cherville, C.-Gilles Trahan.avocat, tie St-Lau-rent, et Raymond Stewart East man, homme d'affaires, de Sutton, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités, le commerce général de courtiers en douanes, expéditeurs transporteurs par terre et par reau, et tie propriétaires de qu lis et entreposeurs, sous le nom de « R.S.Eastman Ltd.», avec un capital total de $19,000.divisé en 190 actions ordinaires d'une valeur au pair tie $100 chacune.Le siège social tie la compagnie sera à Sutton, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 19G0.U Assistant-procureur général adjoint, 56288 P.Frenette.been issued by the Lieutcnant-tiovernor of the Province of Quebec, bearing «late the ninth f«'ssional employers, the artisans and the employees governe«l, by the said «leeree.as per the method and rate mentioned hereinbelow : 1.Assessnieitt.- The period of levy extendi from February 1.1901 to January 31, 1902; the said levy shall be laid us follows: a) The professional employers governed by the suid decree, number 810 and amcndmcnK shall pay t«» the Parity Committee an amount equivalent to } ¦> of \\c/v of their payroll for the employees governed by the said decree.6) The artisans governed by th«- said decree, number 810 and amendments, shall pay to the Parity Committee un amount equivalent t«> } ¦> of 1',',' of the lowest wages « stablisln-d in the decree for journeymen, according t«» their trade. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21 M, mi, Vol.US, No.S 307 c) Les salariés régis par le décret numéro 810 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1 ¦> de 1% de leur rénumération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met ù la dis|x>sition des employeurs professionnels «les formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés pur ledit Comité- paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire ai chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la lin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement impost- ù ses salaries, au moyen d'une retenue sur le salaire «le ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la «late d'expiration «le la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné «le la cotisation de l'employeur professionnel et «les sommes payables au ( 'omité paritaire par s«\\s salariés.Le Comité paritaire a le pouvoir d'exiger Passei-mentation dudit rapport chaque foil qU il h' juge à propos.Le prélèvement imposé par l«' présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus «l'un employeur professionnel ou d'un artisan «le payer ou «le donner les renseignements nécessaires, un avis «le cinq (5) jours lui sera «lonné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi «le la Convention collée- tive, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel «le ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-airaexé, un état «les recettes et des déboursés prévus «lu Comité paritaire des métiers de la construction du district «le Hull, pour la période comprise entre le 1er février 1001 et le l«-r février 1002.Comité i'akitairk des métiers db la CoNBTBltCTlON nu District de IItll Estimé «les recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er février 1901 et le 1er février 1062.Recettes: Cotisations (' £ «le 1%): Employeurs professionnels, artisans et salariés.150,000.00 Honoraires d'examens.500.00 Intérêts sur debentures.5.000.00 S55.500.00 Déboursés: Bureau des examinateurs.8 1,500.00 Jetons de presence.1,500.00 Frais de déplacements «-t «le représentation.1.500.00 Frais d'inspect ions.2,000.00 Salaires.23.000.00 Entretien.500.00 Papeterie.1,000.00 Fonds «le pension aux employés.L150.00 Téléphone, télégrammes, timbres.1,000.00 Délégations.1.000.00 c) The employees governed by the said «lecree, number 810 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to t£ of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the suid Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete an«l sign his report and for-war«l it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the committee, the Basements of his employees by means of a deduction from the latter S wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 15th of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable.The said report shall be sent together with the assessments of the professional employer ami those of the employees.The commet tec has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments laid by the present by-law are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.» Upon refusal by a professional employer or an artisan to pay or to give the necessary infor-mution, five (5) days notice will be given within which he shall fulfil his obligations towards the Purity Committee.3.Financial report Pursuant t«> the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial operations on the following dates: March 31, .bine 30, September 30 and December 81.Hereto annex«-«l is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee for the Building Trades of the district of Hull, for the period between February 1, 1901 and February 1, 1962.Parity committee rOR the Bi ii.ding Thadks of the District of Hill Estimate of the receipts and disbursements for the period between February 1.1901 and February 1.1902.Receipts: Assessments of 1', Professional employers, artisans and employees.$50,000.00 Examination tees.500.00 Bonds interest.5,000.00 .«55,500.00 Disbursements: Board of examiners.$ 4,500.00 Meeting attendance fees.1,500.00 Travelling ami representation expenses.4,500.00 Inspection expenses.2,000.00 Salaries.23,000.00 Maintenance.500.00 Stationery.1.000.00 Pension fuml «>f employees.1,150.00 Telephone, telegrams, stamps.1,000.00 Delegations.1.000.00 308 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 93, A'0 5 Vérification.$ 300.00 Allocution \u2014 autos - inspecteurs.2,700.00 Lover.-.000,00 Frais légaux .1.000 00 Subvention à la Commission «l'Apprentissage des métiers du Bâti- mentde Hull.10,000 00 Divers.2.500.00 «57,010.00 Déficit à être comblé pur réserve.2,110.00 $55,500.00 Le Sous-ministre du Travail, Gkhard Thkmblay.Ministère du Travail, Québec, le 21 janvier 1901.50314-o Avis de modification Employés de garage \u2014 Drummond L'honorable René Hamel, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de lu Loi de la convention collective (S.1LQ.1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de garage dans le district électoral de Drummond, rendue obligatoire par le décret numéro 102 du 31 janvier 1957 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et ù la décision du lieutenant-gouverneur eh* conseil les modifications suivantes audit décret: 1° Le paragraphe b) de l'article II sera remplacé par le suivent: « b) Juridiction territoriale: Le présent décret s'applique au district électoral de Drummond, à l'exception des municipalités de Wickham, l'Avenir, Kingsay Falls et Durham-Sud.» 2° Paragraphe « a » de l'article IV sera remplacé par le suivant: « IV.Taux minima de salaire: a) Pour les fins du présent article, la juridiction territoriale est divisée en deux (2) zones et les taux minima suivants doivent être payés aux salariés ci-après mentionnés: Zone I: La cité de Drummondville et un rayon de Cinq (5) milles de ses limités.Zone 11: lœ reste de la juridiction territoriale.Dans les garages Taux horaires Métiers: Zone I Mécanicien: 1ère classe.$ 1 .55 2ème classe.1.35 3ème classe.1.20 Machiniste ajusteur: 1ère classe.1.55 2ème classe.1.35 3èmc classe.1.20 Débosseur: 1ère classe.1.55 2ème classe.1.35 3èmc classe.1.20 Apprenti (compagnon): 1ère année.0.80 2ème année.0.95 3ème année.1.05 Enlignement et balancement des roues.1.35 Graisseur spécialisé.1.30 Homme de Service.1.10 Homme d'ouvrage général.0.90 Apprentis: (homme de service et homme d'ouvrage général) : 1ère année.0.65 2ème année.0.80 3ème année.0.90 Audition.$ 800.00 Allowance \u2014 autos \u2014 inspectors.2,760.0!» lient.! OO.Oii Legal charges.-.1,000 (M I Subvention to Apprenticeship Commission of the Building Trades of Hull.10,000 00 Miscellaneous.2,500.0u $57,610 Ou Deficit to be covered by reserve.2,1 0.00 $55,500.011 G KHAKI) THKMM.AY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 21, 1961.58314-0 Notice of amendment Oarage employees \u2014 Drummond The Honourable René Humel, the Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments', that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the garage employa* in the electoral district of Drummond, rendered obligatory by the decree number 102 of January 31.1957 and amendments, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments: 1.Paragraph b) of article II will be replaced b\\ the following: \"6) Territorial jurisdiction: The present de crée applies to the electoral district of Drum mond with the exception of the municipalities of Wickham, L'Avenir, Kingsay Falls and Soutli Durham.\" 2.Paragraph \"a\" of article IV will be replaced by the following: 'TV.Minimum rates of wages: a) For the pur poses of the present article, the territorial juris diction is divided into two (2) zones and tie-following minimum rates shall be paid to the employees hereafter mentioned: Zone I: The city of Drummondville and s radius of five (5) miles from its limits.Zone I1: The remainder of the territorial juris- diction.In the garages Per hour Trades: Zones I Mechanic : \u2022 1st class.$ 1.55 2nd class.1.35 3rd class.1.20 Machinist-titter: 1st class.1.55 2nd class.1.35 3rd class.1.20 Rodyworker: 1st class.1.55 2nd class.1.35 3rd class.1.20 Apprentice (journeyman) : 1st year.0.80 2nd year.0.95 3rd year.1.05 Wheel aligning and balancing.1.35 Specialized greaser.1.30 Service-man.1.10 General hand.0.90 Apprentice: (service man and general hand) 1st year.0.65 2nd year.0.80 3rd year.0.90 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1961, Vol.93, So.3 309 Taux hebdomadaires Préposés aux pièces: 1ère année.§35.00 2ème année.30.00 .'{«\u2022nie année.3.\").00 llomiiie en charge.05.00 Assistant.50.00 Assistant «lu gérant «h- s«Tviee .'.45.00 Gardien (préposé à la surveillance et ii l'entretien).I!) 00 Dans 1rs stations de service TOUX horaires Homme «h' service.S 1.10 Apprenti: 1ère année.0.65 2ème année.0.80 Sème année.0.90 Zone II: Les taux minima ci-haut mentionnés sont réduits «le 10.10 l'heure.* 3° L'article IX sera remplacé par le suivant: « IX.Durée du décret: Le présent décret est valable ù compter «le la «late de sa publication -Inns la (iazette officielle de Québec et «lemeure en vigueur jusqu'au 30 septembre 1901.Il se renouvelle automati«piem«'iit «l'année en année par lu suite, à moins que l'une «h s parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire dans un délai qui ne «loit pas être «le plus «le soixante (00) ni «le moins «le tranté (30) jours avant le 30 septembre de l'année 1901 ou «le toute année subséquente.In tel avis d it également «*'trc adressé au Ministre du Travail.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans umendemeut.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la «late «le sa publient ion dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter «le la «late de publication de cet avis «lans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre «lu Travail recevra l'es objections «pic les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail.Gkkaku Thkmblay.Ministère «lu Travail, Québec, le 21 janvier 1901.50314-o Avis de modification Horlogerie et bijouterie Certaines régions de la province L'honorable René Humel, ministre du Travail, donne avis par les- présentes, conformément sus dispositions de la Loi «le la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), que les parties contractantes ù lu convention collective «le travail relative aux métiers d'horloger et de bijoutier «lans certaines régions «le lu province, rendue obligatoire par le décret numéro 1G3 «lu 12 février 1948 et amendement, lui ont présenté une requête ù l'effet d'apporter les modifications suivantes audit décret: 1° L'article II sera remplacé par le suivant: « IL Juridiction professionnelle: Le décret régit les métiers d'horloger et de bijoutier et les autres emplois tels que définis à l'article précédent.Exemptions: Toutefois, le présent décret ne s'applique pas aux commis travaillant dans un per week Parts department employee: 1st year.$T>.00 2nd year.30.(M) 3rd year.85.00 Head clerk.65.00 Assistant heml clerk____ .50.00 Service manager assistant.45.00 Watchman (watching and miintenanon) 40.00 In Service Stations Per hour Service man.$ 1.10 Apprentice: 1st year.0.05 2nd year.0.80 3rd year.0.90 Zone 11: The above minimum rates shall be reduced by SO.10 per hour.\" 3.Article IX will be replaced by the following: \"IX.Duration of the decree: The decree comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and remuins clfective until September 30.1901.It then renews itself automatically from year to year unless a notice cf termination be served by one party hereto to the other within the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day prior to September 30 of the year 1901 or of any subsequent year.Such a notice shall also be filed with the Minister of Labour.\" The publication of the present notice docs not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only he rendered obligatory by an Ordcr-in-Council which comes into force on the «late of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication t)f this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.Gkhahd Thkmblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 21.1901.50314-o Notice of amendment (loclcmaker and jeweller trades ¦Certains districts of the Province The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions «>f the Collective Agreement Act (R.S.Q.1911, chapter 103 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the 'clockmaker and jeweller trades in certain «listricts of the Province, rendered obligatory by the decree, number 103 of February 12, 1948 ami amendments, have petitioned 'him to submit to the consideration nntl decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said «lecree: 1.Article II will be replaced by the following: \"II.Professional jurisdiction: The decree governs the clockmaking and jewelry trades and other occupations as defined in the foregoing article.Exemptions: However, the present decree does not apply to clerks working in a commercial 310 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI janvier 1961, Tome 93, N° 8 établissement commercial généralement reconnu comme un magasin à rayons, Le décret ne régit pas non plus les établissements faisant exclusivement du travail en série de fabrication et d'assemblage d'articles de bijouterie et d'horlogerie.» 2° L'article III sera remplacé par le suivant : c III.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du présent décret comprend tous les comtés «le la province de Québec, sauf ceux qui sont situés dans l'Ile «le Montréal, les comtés de Saint-Hyacinthe et Hull.» 3° L'article IV sera remplacé par le suivant: « IV.Heures de travail: La durée régulière de travail des salariés régis par le décret est de quarante-huit (48) heures par semaine réparties comme suit: entre 9.00 a.m.et 6.00 p.m.les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi et entre 9.00 a.m.et 10.00 p.m.le vendredi.En aucun temps l'employeur ne peut faire travailler ses s dariés en dehors de l'horaire mentionné ci-haut si ce n'est pendant la période des fêtes, soit quatre (4) jours ouvrables avant le 24 décembre en plus du vendredi soir où le travail est permis, jusqu'à 10.00 p.m.» 4° L'j rîicle V sera remplacé par le suivant: «V.Travail .supplémentaire: Tout travail exécuté en plus du nombre d'heures déterminées ou en dehors «le l'horaire fixé à l'article IV, est considéré comme du travail supplémentaire et doit être rémunéré au taux de salaire et demi basé sur le salaire réel payé au salarié concerné.» 5° L'article VI sera remplacé par le suivant: « VI.Taux minima de salaires: Les taux minima de salaires pour la semaine régulière de travail sont les suivants: par semaine Horloger-senior.S65.00 Bijoutier-senior.65.00 Horloger-junior.55.00 Bijoutier-junior.55.00 Graveur.55.00 Sertisseur.55.00 Soudeur.55.00 Plaqueur.55.00 Polisseur.55.00 Bruuisseur.55.00 Commis: Femmes Hommes 1ère année.$31.00 $31.00 2ème année.33.00 33.00 3ème année.35.00 35.00 4ème année.40.00 5ème année.50.00» 6° L'article VII sera remplacé par le suivant: « VIL Dispositions spéciales: Toute rémunération doit être payée conformément aux dispositions du décret.Tout contrat à commission est illégal s'il établit des taux inférieurs aux minima spécifiés «lans le décret.L'employeur qui utilise les services d'un ouvrier de métier qualifié doit lui garantir un minimum de trente (30) heures de travail par semaine.» 7° Les mots « après trois (3) années de service » apparaissant au premier paragraphe de l'article VIII (Vacances Payées) seront tempîacés par les mots « après deux (2) années de service ».8° Le paragraphe « c » de l'article IX sera remplacé par le suivant: « e) Taux de salaires minima: Les taux de salaires hebdomadaires des apprentis pour la durée régulière de travail sont les suivants: establishment generally known as a department store, nor does it apply to the employees of establishments engaged exclusively in the production and assembling of articles of jewellery and clockmaking.\" 2.Article III will be replaced by the following: \"III.Territorial jusidiction: The territorial jurisdiction of the present decree comprises ull the counties of the Province of Quebec, with the exception of those situate in the Island of Montreal, and of the counties of St.Hyacinthe and Hull/' 3.Article IV will be replaced by the following ; \"IV.Hours of work: The standard duration of work of employees governed by the decree shall be forty-eight (48) hours per week distri-buted as follows: Between 9.00 a.m.and 6.00 p.m.on Monday, Tues«luy, Wednesday, Thursday and Saturday, and between 9.00 a.m.and 10.00 p.m.on Friday.The employer shall never cause his employees to work outside the hours mentioned above, except during the holidays |>erioy the decree shall sj>en«l, studying the trade, at least: 25% of the regular duration of work in the course of their first j'eur of apprenticeship; 50% of the regular duration i«ler the objections which the interested parties may wish to set forth.Gérard Tremblay, 'Deputy Minister of labour.Department of Labour, Quebec, January 21, 1961.56314-0 Notice The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments) that, in pursuant of Order in Council number 154 (D) of January 17, 1961, the constitution and general\" by-laws of the Joint Commission for the Dress Industry of the Province of Quebec, approved by Order in Council number 3985 of November 7, 1940, have been repealed and replaced by a new constitution and new general bylaws.Gérard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 21, 1961.56314-o Arrêtes en Conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 58 Section « A » Québec, 10 janvier 1961.Présent: I/c lieutenant-gouverneur en conseil.< 'oncernant des modifications au décret relatif au commerce de détail de la fourrure dans la région de Montréal.Orders in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 58 Section « A » Quebec, January 10, 1961.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the retail fur trade in the region of Montreal. 312 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 93, N° S Attendu que< conformément aux dispositions de lu Loi de la convention collective (Statuts refondus «le Québec Util, chapitre 103 et amendements), les parties contractantes à la convention collective «le travail relative à l'industrie «le la fourrure) section «lu détail, région »!yeur établit l'horaire des journées régulières «le travail selon ses besoins.Toutefois, il doit en donner avis par écrit et par malle recommandée au Comité Paritaire.À défaut de faire parvenir un tel avis au Comité Paritaire, «celui- the retail fur trade in the region of Montreal, have petitioned the Minister of Labour to .submit to the consideration and decision of the-Lieutenant-Governor in Council some amendments to the decree number 643 of Muy 20, 1063 and amendments; \u2022 whereas the said petition has been published in \"the Quebec Official Gazelle, issue of November 20, 1000; whereas no objection has been made against the approval «;f the proposed omcn«lments; It ib ORDERED, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 643, be amend* il as follows: .1.Article III is deleted and replaced by the following: \"111.Duration of work: a) Standard work week: The standard work week shall consist f forty (40) hours, divided into days of right B hours each, worked between 8.C0 a.m.and 12.< 0 p.m.(noon) and 1 .CO p.m.and G.CO p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.Employers may .establish the hours of the standard work day according to their needs.However, they shall notify the Parity Committee by registre red letter.Failing such notification, the Committee shall then consider the work week as being distributed between 8.00 a.m.and 12.C0 (noon) ami between 1.00 p.m.ami 5.00 p.m.b) Overtime at time and a half: 1.All time worked beyond these hours is considered as overtime and pai«l -for at the rate of time and one half the year round.Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, an employee late to work by his own fault shall complete the repu'ar number of working hours for that day before being entitled to the time-ami a half rate.2.There shall be no overtime between June 1 and Labour Day.3.Employees arc free to accept or refuse to work overtime.4.Employers shall not give fur trade work to be executed outside their establishment except when employees refuse to work overtime or cannot, even when working overtime, do in time all the work of their employers.5.However, employers shall report to the Parity Committee all work done outside the shop and give the name and address of all persons or contractors or sub-contractors to whom the work was given.1 c) Overtime paid straight time but with guarantee of compensation in hours of work: 1.Notwithstanding the foregoing provisions, employers may have overtime worked by their employees at straight time providing they notified the Parity Committee by registered letter to that effect and providing they comply with the following conditions.2.Employees are free to accept or refuse to work overtime.3.There shall be no overtime between June 1 and Labour Day. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1001, Vol.03, No.8 313 I.La limite du travail supplémentaire uu taux simple s'étend jusqu'à 9.00 p.m.les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi inclusivement il de 8.00 a.m.à 5.00 p.m.le samedi.Tout travail exécuté uprès cette limite d'heures doit êl re rémunéré à taux et kemi.5.L'employeur doit fournir deux (2) heures .!\u2022\u2022 travail l'année suivante pour chuque heure de travail supplémentaire fuit ù taux simple !entures ami other securities.The head office of the said company in the Province is to be established at Cedarvale, Aylmer, judicial district of Hull.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company, is Mr.John E.Riddell.of the above-given address.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth day of January, 1961.Raymond Douville, 56288-0 Assistant Secretary of the Province.(A.G.14643-60) Association Canadienne d'Édition, Ltée By-law No.3 increasing the number of the directors of \"Association Canadienne d'Édition, Ltée\".It has been unanimously resolved 1.That the number of directors of \"Association Canadienne d'Édition, Ltée\" be changed from seven (7) to nine (9).2.That the two vacancies which will be created on the Board of Directors by the adoption of this by-law after it has been ratified by the company's share-holders and published, in conformity with section 84 of the Quebec Companies Act, in the Quebec Official Gazette be filled by the directors then in office until the next annual general or special meeting of the shareholders of the company.I, Taschereau Fortier, secretary, certify that the above text is a true and exact copy of by-law number 3 of the said company which was unanimously adopted by its directors, all present, at a meeting duly convoked and held at Montreal, on November 13, 1960, and ratified on the same day by the sahreholders, all present, at a special general meeting.(Seal) Taschereau Fortier, 56300 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 98, N° 8 (P.G.17303-52) A.Bélanger Limitée Eîglemeut N° 27 Il est décrété à titre de règlement de la compagnie: 1.Le nombre «les directeurs de la compagnie est augmenté de sept (7) ù onze (11); 2.Dès que le présent règlement sera entré en vigueur, les directeurs en fonctions pourront nommer quatre (4) directeurs additionnels pour demeurer en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.Copie fidèle d'un règlement adopté par les directeurs de « A.Uélunger Limitée », le 2 décembre 19G0, et approuvé à l'unanimité par les actionnaires de ladite compagnie à une assemblée générale spéciale convoquée aux fins de considérer ledit règlement et tenue le même jour.« A.Bélunger Limitée », Par le Secrétaire, 5G301-o (signé) Marcel Piciik.(P.G.14143-58) Montreal Dog Obedience Training Club Inc.Extrait des règlements de la compagnien am-méc ci-dessus, tels qu'adoptés à l'assemblée générale spéciale tenue le 14 septembre 19G0, concernant une augmentation des membres du Conseil d'administration, de trois ai cinq: « Règlement Trois \u2014 Conseil d'administration \u2014 Article 1, nombre.Le Conseil d'administration sera cemposé de cinq directeurs.» Vraie copie certifiée.Le Secrétaire, 56302 A.Slaughter.(P.G.15068-51) New York Hat Frame Ltd.Règlement spécial « A » Que le nombre des directeurs de la compagnie soit diminué de quatre à trois.Décrété ce 13e jour de décembre 1960.Vraie copie certifiée.Lê Secrétaire, 46303 Stella Szuszkowski.L'Association des Employés de la Cie Gagnon Ltée Avis est donné que le Secrétaire de la province a, le 22 décembre 1960.autorisé la constitution d'un syndicat professionnel sous le nom de « L'Association des Employés de la Cie Gagnon Ltée».Le siège social du syndicat professionnel ci-haut mentionné est situé à Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le vingt-neuf décembre 1960.Le Sous-secrétaire de la province, 56309-o Raymond Douville.L'Association des Employés d'Hamel Transport Ltée Avis est donné que le Secrétaire de la province a, le 22 décembre r960, autorisé la constitution d'un syndicat professionnel sous le nom de c L'Association des Employés d'Hamel Transport Ltée ».Le siège social du syndicat professionnel ci-haut mentionné est situé à Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le vingt-neuf décembre 1960.Le Sous-secrétaire, de la province, 56310-o Raymond Douville.(A.G.17303-52) \u2022 A.Bélanger Limitée By-law No.27 Be it enacted as a by-law of the company: 1.The number of directors of the company i.-.iiien as d from seven (7) to eleven (11); 2.I'ikhi the coming into force < f this by-law.the directors then in office shall be entitled to appoint four (4) additional directors to held office until their successors are elected.Certified true copy of a by-law enacted by the directors of \"A.Bélanger Limitée\" on December 2, 1960, and unanimously upproved by the shareholders of the said company at a special general meeting called for considering the said by-law and held on the same day.\"A.Bélanger Limitée\", (signed) Per: Marcel Piciifc, 56301 Secretary.(A.G.14143-58) Montreal Dog Obedience Training Club Inc.Extract of.the by-laws of the above-named corporation, as adopted at the special general meeting held on September 14, 1960, concerning an increase in the directorate from three to five: \"By-law Three \u2014 Board of directors \u2014 article 1., number.The Board of Directors shall consist of five directors.\" Certified true copy.A.Slaughter, 56302-o Secretary.(A.G.15068-51) New York Hat Frame Ltd.Special By-law \"A\" That the number of directors of the company be decreased from four to three.Enacted this 13th day of December, 1960.Certified true copy.Stella Szuszkowski, 56303-o Secretary.L'Association des Employés de la ' Cie Gagnon Ltée Notice is given that the Provincial Secretary has, on December 22, 1960, authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"L'Association des Employés de la Cie Gagnon Ltée\".The head office of the professional syndicate above mentioned is situated at Saint-Félicien, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, on December twenty-ninth, 1960.Raymond Douville, 56309 Assistant Secretary of the Province.L'Association des Employés d'Hamel Transport Ltée Notice is given that the Provincial Secretary has.on December 22, 1960, authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"L'Association des Employés d'Hamel Transport Ltée\".The head office of the professional syndicate above mentioned is situated at Saint-Félicien, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, on December twenty-ninth, 1960.Raymond Douville,- 56310 Assistant Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1001, Vol.08, No.3 317 645 Wellington Corporation Sommaire du règlement .spécial « A » I^e règlement spécial « A » passé par les directeurs de « 645 Wellington Corporation », le Il octobre 1960 |>ourvoit à la distribution de tout l'actif de la compagnie, au pro rata entre \u2022es actionnaires et autorise les officiers de lu .'ouipugnic ù exécuter tous les actes nécessaires ,i cette fin.(Sceau) 645 Wellington Corporation, Par le Secrétaire, .(1315 W.WllYTE.(P.6.13161-60) Rolland Drolet Limitée BèglemetU N° 4 Règlement concernant la modification du nombre des directeurs.Le nombre des directeurs de la compagnie l Rolland Drolet Limitée » est changé de quatre i!) qu'il était auparavant à celui de trois (3) et les lettres patentes de la compagnie sont modifiées en date du 2 août 1960 en conséquence.Copie certifiée du règlement N° 4 dûment adopté à une assemblée des directeurs tenue le vingt-deuxième jour d'octobre 1960, et approuvé à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le 22ième jour d'octobre 1960 par les actionnaires détenant entre eux (100%) des actions représentées à cette assemblée.Le Secrétaire, ô(i318-o Rosakio Laurexdeau.645 Wellington Corporation Summary of special by-laic \"A\" Special by-law \"A\" passed by the directors of \"645 Wellington Corporation\" on October 31, 1960 provides for the distribution of all the assets of the company pro rata among its shareholders and authorizes the officers of the company to take all such action as may be required for such purpose.(Seal) 615 Wellington Ccyporation, By: W.Wiiyte, 56315-o Secretary.(A.G.13161-60) Rolland Drolet Limitée By-law No.4 By-law concerning the amendment in the number of directors.The number of the directors of the company \"Rolland Drolet Limitée\" is changed from four (4) that it was heretofore to that of three (3) and the letters patent of the company are therefore amended under date of August 2, 1960.Certified copy of by-law No.4 duly adopted at a meeting of the directors held on the twenty-second day of October, 1960, and approved at a special general meeting of the company held on the 22nd day of October.1960 by the shareholders holding among themselves (100%) of the shares represented at this meeting.Rosahio Lauren deau, 563IS Secretary.La Champlain, Compagnie d'Assurances Générales Avis de changement de nom Avis est par les présentes donné que le lieutenant-gouverneur en conseil, par l'arrêté numéro ¦r>2, sanctionné le 10 janvier 1961, a changé, en conformité des dispositions de l'article 93 de la Loi des assurances de Québec, le nom de « La Champlain, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Champlain General Insurance Company » en celui de « La Progressive Compagnie d'Assurance\u2014 The Progressive Insurance Company », à compter du 10 janvier 1961.Donné à Montréal, le 16 janvier 1961.Le Secrétaire-trésorier, 56319-0 J.J- Milord.Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Canadian Wiper Corporation) Avis est donné que le Secrétaire de la province n, le 31 octobre 1960, autorisé la constitution d'un syndicat professionnel sous le nom de «Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Canadian Wiper Corporation) ».Le siège social du syndicat professionnel ci-haut mentionné est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province le onze janvier 1961.Le Sous-secrétaire de la province, 56827*0 Raymond Douville.The Champlain General Insurance Company Notice of change of name Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in Council, by the order number 52, assented to the 10th of January, 1961, has changed, in accordance with the provisions of section 93 of the Quebec Insurance Act, the name of \"The Champlain General Insurance Company \u2014 La Champlain, Compagnie d'Assurances Générales*' to that of \"The Progressive Insurance Company \u2014 La Progressive Compagnie d'Assurance\", as from the 10th of January, 1961.Given at Montreal, on the 16th of January, 1961.f J.J.Milord, 56319-o Secretary-Treasurer.Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Canadian Wiper Corporation) Notice is given that the Provincial Secretary, on October 31, 1960, has authorized the organiz-.ing of a professional syndicate under the name of \"Association des Employés, de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Canadian Wiper Corporation)\".The head office of above-mentioned professional syndicate is situated in Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this eleventh day of January, 1961.Raymond Douville, 56327 Assistant Secretary of the Province. 318 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1061, Tome 98, N° 8 Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Hector Jolicoeur Inc.) Avis est donné que le Secrétaire de la province a, le 31 octobre 1900.autorisé la constitution d'un syndicat professionnel sous le nom de « Association des Employés de Service de taxation de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Hector Jolicoeur Inc.) ».Le siège sociul du syndicat professionnel ci-buut mentionné est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureuu du Secrétaire de la province, le onze janvier 1961.Le Sous-secrétaire de la province, 56328-0 Raymond Douville.Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Roger Laverdure Ltée) Avis est donné que le Secrétaire de la province s, le 31 octobre 1960, autoiisi la constitution d'un syndicat professionnel sous le nom de \u2022 Association des Employés de Service de Location de TabHers, Serviettes etc.Inc.F.C.A.I.(Roger laverdure Ltée) ».Le siège social du syndicat professionnel ci-haut mentionné est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le onze janvier 1961.Ijc Sous-sccri luire de la province, 56329-o Raymcnd Douville.Association de* Instituteurs Catholiques de la Vallée de la librae Avis est donné que le Secrétaire de la province a, le 4 janvier 1961, autorisé la constitution d'un syndicat professionnel scus le nom de « Association des Instituteurs Catholiques de la Vallée de la Lièvre ».Le siège social du syndicat professionnel ci-haut mentionné est situé à Buckingham, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le onze janvier 1961.Ix Sous-secrétaire de la province, 56330-o Raymond Douville.Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Hector Jolicoeur Inc.) Notice is given that the Provincial Secretary on October 31, 1960, has authorized the organi/ ing of a professional syndicate under the name < \"Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Hector Jolicoeur Inc.)\".The head office of above-mentioned professional syndicate is situated in Montreal, jmliei.district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this eleventh*day of January, 1961.Raymond Douville, 56328 Assistant Secretary of the Province.Association des Employés de Service de Local ion de Tabliers, Serviettes, etc.lue.F.C.A.I.(Roger Laverdure Ltée) Notice is given that the Provincial Secretary, on October 31, I960, has authorized the organizing of a professional syndicate under the name \"Association des Employés de Service de Location de Tabliers, Serviettes, etc.Inc.F.C.A.I.(Roger Laverdure Ltée)\".The head office of above-mentioned profession al syndicate is situated in Montreal, judicial district of Mont real.Given at the office of the Provincial Secretary, this eleventh day of January, 1961.Raymond Douvillk, 56329 Assistant Secretary of the Province.Association des Instituteurs Catholiques-dé la Vallée de la Lièvre Notice is given that the Provincial Secretary, on January 4, 1961, has authorized the formation of a professional syndicate under the name o( \"Association des Instituteurs Catholiques de la Vallée de la Lièvre\".The head office of the above-mentioned professional syndicate is situated at Buckingham, judicial district of Hull.(.iiven at the office of the Provincial secretary, this eleventh day of January, 1961.Raymond Douvillk, 56330 Assistant Secretary of the Province.Syndicat de Travail de Val Senneville Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif « Syndicat de Travail de Val Senneville », en date du 27 décembre 1960, dont le siège social est situé à Val Senneville, comté d'Abitibi-Est, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le douze janvier 1961.Le Sous-secrétaire, de la province, 56334-o Raymond Douville.La Caisse Populaire de St-Jude Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif « La Caisse Populaire de St-Jude », en date du 1er janvier 1961, dont le siège social est situé à Saint-Jude, comté de Syndicat de Travail de Val Senneville Notice is hereby given that the Hnnourahh the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat de Travail de .Val Senneville\", under date December 27, 1960, whereof the head office is at Val Senneville, county of Abitibi-East, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Sccre tary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twelfth day of January, 1961.Raymond Douville, 56334 Assistant Secretary of the Province.Lu Caisse Populaire de St-Jude Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de St-Jude\", under date January 1st, 1961, whereof the head office is at Saint- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1901, Vol.93, No.3 319 Saint-Hyacinthe, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le douze janvier 1961.Le Sous-sécréta ire de la province, 56335-0 Raymond DoirviLLK.(P.G.4605-50) Bolton, Tremblay & Company Bolton, Tremblay & Compagnie Règlement spécial « E » Qui est un règlement pour augmenter les membres du conseil d'administration de trois (3) à quatre (4) : « Qu'il soit décrété, et il est, par les présentes, décrété comme le règlement spécial « E » de la compagnie que: 1° Le nombre des membres du conseil d'administration de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois à quatre; 2° Le règlement général III, article 1 de la compagnie soit et il est, par les présentes, amendé pour se conformer au précédent.» Je, Claire Chartrand, secrétaire de « Bolton, Tremblay & Company », certifie, par les présentes, que le précédent règlement est une copie véritable du règlement spécial « E » de la compagnie, dûment décrété à l'unanimité le 20e jour de juin 1960, par tous les directeurs de « Bolton, Tremblay & Company », à une assemblée des directeurs et que ledit règlement a été dûment approuvé, ratifié, confirmé et sanctionné subséquemment le 30e jour tie juin 1960.par le vote unanime de tous les actionnaires de la compagnie, à une assemblée générale spéciale des actionnaires.Signé et daté à Montréal, ce 13e jour de janvier 1961.Le Secrétaire, 56358 Claire Chartrand.Jude, county of Saint-Hyacinthe, and that the said document bus been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twelfth day of January, 1961.Raymond Doitvillk, 56335 Assistant Secretary of the Province.(A.G.4605-50) Bolton, Tremblay & Company Bolton, Tremblay & Compagnie Special by-law \"A\"' Being a by-law to increase the board of directors from three (3) to four (4): \"Be it enacted, and it is hereby enacted as special by-law \"E\" of the company that: 1.The number of the board of directors of the company be and it is hereby increased from three to four; 2.The general by-law III, article 1 of the company be and it is hereby amended to accord with the foregoing.\" I, Claire Chartrand, secretary of \"Bolton, Tremblay & Company\", do hereby certify that the foregoing by-law is a true copy of special by-law \"E\" of the company, duly and unanimously enacted on the 20th day of June, 1960 by all the directors of \"Bolton, Tremblay & Company\", at a meeting of directors and that the said by-law was subsequently, on the 30th day of June, 1960, duly approved, ratified, confirmed and sanctioned by the unanimous vote of all the shareholders of the company, at a special general meeting of shareholders.Signed and dated at Montreal, this 13th day of January, 1961.Claire Chartrand, 56358-0 Secretary.Chartes \u2014 Abandon de La Compagnie de Filtration St.Maurice Ltée Avis est par la présente donné que « La Compagnie de Filtration St.Maurice Ltée », demandera, par requête adressée à l'honorable Procureur général de la Province, la permission d'abandonner sa charte.Trois-Rivières, Que., ce 21e jour de janvier 1961.Le Procureur de la compagnie, 56304-o (Signé) Charles Coderre, c.r.Ralliement des Terres Ltée.Avis est par les présentes donné que « Ralliement des Terres Ltée.», qui a son bureau principal dans la Ville de Côte St-Luc, Province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte en - vertu de la Loi des compagnies de Québec.Montréal, P.Q., le 12 janvier, 1961.Les Procureurs des requérants, 56305-o Cerini & Jamieson.Charters \u2014 Surrender of St.Maurice Filtration Company Ltd.Notice is hereby given that \"St.Maurice Filtration Company Ltd.\", shall, by way of petition of the Honourable Attorney-General of the Province of Quebec, request permission to abandon its charter.Three Rivers, Que., this 21st, day of January 1961.(Signed) Charles Coderre, q.c, 56304-o Attorney for the company.Ralliement des Terres Ltée.Take notice that \"Ralliement des Terres Ltée.\", with head office in the city of Côte St.Luc, Province of Quebec, will apply for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, P.Q., the 12th day of January* 1961.Cerini & Jamieson, 56305-o Attorneys for petitioners., Compagnies dissoutes (P.G.14284-60) Conga va Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec et Companies Dissolved (A.G.14284-60) Congava Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Companies Mining Act and 320 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 93, N\" S de la première partie tie la Loi ties compagnies de Québec, Statuts refondus tie Québec, 1041, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi des compagnies tic Québec, il a plu uu Procureur général d'accepter l'abandon tie la charte tie la compugnie «Congavu Mines Limited» (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi ties compagnies minières tie Québec, pur lettres patentes en date du 25 février 1957.Avis est tic plus donné qu'à compter du trente décembre 19(50, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1961.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-0 P.Frenette.(P.G.14747-60) Dowler Development Company Avis est donné qu'en vertu tic la première partie tie la Loi des compagnies tie Québec, Statuts refondus tie Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité tlécrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'uoeepter l'abandon de la charte tie la compagnie « Dowjer Development Company », constituée en corporation en vertu tie ladite première partie de la Loi tics compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 1er mars 1929.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un décembre 1960, ladite compapnie a été dissoute.Daté tlu bureau du Procureur général, le neuf janvier 1961.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-0 P.Frenette.(P.G.10453-60) Frontenac Holdings Limited Avis est \u2022 donné qu'en vertu tie la première Êartic de la Loi des compagnies tie Québec, ta tu t.s refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 tie ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie « Frontenac Holdings Limited », constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Quéhec, par lettres patentes en date \u2022 du 10 avril 1928.Avis est tie plus donné qu'à compter du trente et un décembre 1960, ladite compagnie a été dissoute.Daté tlu bureau du Procureur général, le neuf janvier 1961.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-0 P.Frenette.* _ (P.G.14423-60) Godard Shoe Products Inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première Cie de la Loi des compagnies de Québec, uts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie « Godard Shoe Products Inc.», constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 25 avril 1945.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un décembre 1960, ladite compagnie a été dissoute.Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleused to accept the surrentier of the charter of the compuny \"Conga va Mines Limited\" (No Personal Liability), incorporated untler suid Quebec Mining Companies Act, by letters patent dated February 25.1957.Notice is also given that from and after December thirtieth, 1960, the said company has been dissolved.Datetl at the office of the Attorney General, this third day of January, 1961.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.14747-60) Dowler Development Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, sectitin 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been plcasyl to accept the surrender of the charter of the company \"Dowler Development Company\", incorporated under saitl Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated March 1st, 1929.Notice is also given that from and after December thirty-first, 1960, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1961.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.10453-60) Frontenac Holdings Limited Notice is hereby given that under Part Tof the Quebec Companies Act, section 26, chapter 176, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Frontenac Holdings Limited\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated April 10, 1928.Notice is also given that from and after December thirty-first, 1960, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1961.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.14423-60) Godard Shoe Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the saitl Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Godard Shoe Products Inc.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated April 25, 1945.Notice is also given « that from and after December thirty-first, 1960, the said company has been dissolved. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1961, Vol.03, No.3 321 Daté\" du bureau du Procureur general, le neuf Janvier 1901.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-0 P.Pbkkbttk.(P.G.16865-59) Graham Boulevard Realty Corp.Avis est donne qu'en vertu «le la première partie de la Loi del compagnies de Québec, Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie « Graham Boulevard Realty Corp, », constituée en corporation en vertu de ladite première partie de lu Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 5 octobre 1955.Avis est de plus donné qu'à compter du trente ot un décembre 1900, ladite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau du Procureur général, le neuf janvier 1901.l L'Assistant-procureur général adjoint, 5fi288-o P.Frenette.(P.G.12734-00) Lake Bcauport Industries Ltd -Les Industries Lac Beauport Ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, Statuts refondus «le Qu«;bec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie « Lake Beauport Intlustries Ltd \u2014 Les Industries Lac Beauport Ltée », constituée en corporation en vertu de hulitc première partie «le la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en «late du 3 février 1955.Avis est de plus donné qu'à compter du trente décembre 1960, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1961.L'Assistant-procureur général adjoint, 56288-0 1».Frenette.Date«l at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1961.P.Frenette, 56288 Assistant Deputy Attorney General.(A.G.15865-59) Graham Boulevard Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 26, chapter 276, R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attor-nay General has been pleased to accept the surrender of t he chai ter of the company \"Graham Boulevard Really Corp.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated October 5, 1955.Notice is also given that from an«l after December thirty-first, 1960, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this ninth ec be author iacd to borrow the following amounts subordi hately under the approval of the Quebec Municipal Commission and of the Minister of the Municipal Affairs: a) $300.000.00 to be spent annually during « period of three years, from May 1st, 1961, lor tlie construction and the replacement of perma nent pavements; b) $750.000.00 for the finishing of the Charest Boulevard, comprised therein the acquisition of the immoveables required; c) $500,000.00 for the extension\" of the St Cyrille Boulevard, comprised therein the acqui sit ion of the immoveables required; d) $400,000.00 for the construction of the Champlain Boulevard, along the St-Lawrcncc River, upon the condition however, that an understanding be made between the Federal.Provincial and City Governments for the realization of this undertaking; e) $500,000.00 for the construction of an immoveable destined to serve as general headquarters for the Quebec Municipal Police; To modify the Act allowing the City to use for purposes other than those originally provided for the balance of all the loans which it has been authorized to make by the Legislature or by the electors who are property owners and for which the City has no need for the purpose for which these funds were destined; To modify the imposable licence to auctioneers of articles of jewellery or time-pieces; To modify the imposable licenee on automatic distributors; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January Slat, 1961.Vol.93, So.3 323 Pour permette, sur paiement d'une licence, et réglementer le commerce de vivres et/ou de breuvages dans des cantines mobiles dans les limites de la cité; Pour modifier la loi régissant les fonds de pension et pensions de retraite des fonctionnaires du Service intérieur de la Cité de Québec; Pour soustraire certains propriétaires à l'obligation de construire des trottoirs duns une zone où un centre d'achats a été construit à l'ouest du l'are de I'Kxposition; Pour demander l'autorisation d'établir et de constituer en corporation une Commission de stationnement qui uura juridiction pour administrer les terrains acquis pur la Cité pour l'établissement de terrains de stationnement; Pour réduire à quarante-cinq pieds la largeur de la rue Kirouac entre la rue Dieppe et la rue Verdun et céder à l'un ou l'autre des propriétaires riverains la lisière de terrain qui par la suite ne fera pas partie du domaine public; Pour autoriser la Cité ù garantir, jusqu'à concurrence d'une somme de $50,000.00, les dépenses ;i encourir pour la réalisation d'un spectacle lumineux et sonore connu sous le nom de « Son 11 Lumière » et qui sera évocatcur de l'histoire de Québec ou se rapportera à des événements, manifestations ou fêtes qui lui sont propres; Pour édicter une législation de nature à protéger contre toute pollution le territoire où se trouvent les sources d'alimentation d'aqueduc de la Cité de Québec; Et tous autres amendements qui peuvent être ilans l'intérêt de la Cité de Québec et de ses contribuables.Les Avocats de la Cité de Québec, Pelletier, Goobout 56267-2-4-0 & Leclerc.To allow, upon the payment of a licence, and to regulate the business dealing in foodstuffs and/or in beverages in mobile canteens within the limits of the city; To modify the act governing the pension funds and retirements pensions of the employees of the Interior Service of the City of Quebec; To withdraw from certain property owners the obligation to construct sidewalks in a zone where a purchusing center bus been erected at the west of the Exhibition Park; To apply or the authorization to establish and to incorporate a Parking Commission which will have the jurisdiction to administrate the lot of land acquired by the City for the establishment of parking lots; To reduce to forty-five feet the width of Kirouac Street between Dieppe Street and Verdun Street and to cede to one or the other of the riparian property owners the strip of land which afterwards will not form part of public property; To authorize the City to guarantee, to the amount of $50.000.00, the expenses to be incurred for the realization of a luminous and sound spectacle to be known tinder the name of \"Sound and Light\" and which shall recall the history of Quebec or which shall pertain to such events, manifestations or festivals proper to its history of the City; To enact a legislation of such nature as to protect against all pollution the territory where springs are to be found emptying into the aqueduct of the City of Quebec; And all other amendments which may be in the interest of the City of Quebec and of its ratepayers.Pelletier, Goobo*ut & Leclerc, 50267-2-4 Advoeatea for the City of Quebec.La Corporation de Montréal Métropolitain Avis est, par les présentes, donné que « La Corporation de Montréal Métropolitain », constituée en corporation par la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre 52, section II, ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi pour modifier les lois 11 George V, chapitre 140, 12 George V, chapitres 123 et 124, 13 George V, chapitre 105, 14 George V, chapitre 107, 15 George V, chapitre 115, 16 George V, chapitre S2, 18 George V, chapitre 120, 19 George V, chapitre 103.20 George V, chapitre 147, 21 George V, chapitre 139, 22 George V, chapitre 129, 23 George V, chapitre 141, 13 George VI, chapitre 77, 14-15 George VI, chapitre 73, 1-2 Elizabeth II, chapitré 60, 3-4 Elizabeth II, chapitre 125,7-8 Elizabeth II, chapitre 52, section II, et 8-9 Elizabeth II, chapitres 105 et 106, en vue: 1° D'insérer des dispositions interprétatives et des modifications de concordance; 2° De fixer un délai d'appel à la Commission Municipale de Québec relativement aux évaluations totales modifiées par la corporation; 3° D'amender les procédures d'emprunts et certaines dispositions concernant la perception des répartitions; The Montreal Metropolitan Corporation Notice is hereby given that \"The Montreal Metropolitan Corporation\", constituted as a corporation by the Act 7-8 Elizabeth II, chapter 52, division II, having its head office and principal place of business in the city of Montreal, shall apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to obtain the adoption of an act to amend the Acts 11 George V, chapter 140, 12 George V, chapters 123 and 124, 13 George V, chapter 105, 14 George V, chapter 107, 15 George V.chapter 115, 16 George V, chapter 82, 18 George V, chapter 120, 19 George V, chapter 103, 20 George V, chapter 147, 21 George V, chapter 139, 22 George V, chapter 129, 23 George V, chapter 141, 13 George VI, chapter 77, 14-15 George VI, chapter 73, 1-2 Elizabeth II, chapter 60, 3-4 Elizabeth II, chapter 125, 7-8 Elizabeth II, chapter 52, division II, and 8-9 Elizabeth II, chapters 105 and 106, so as: 1.To insert therein certain interpretative provisions and certain amendments accordingly; 2.To set a delay in appeal to the Quebec Municipal Commission with regard to total appraisals modified by the corporation; 3.To amend borrowing procedures and certain provisions concerning the collection of apportionments; 824 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1061, Tomé 03, N° 3 4° D** changer certaines dispositions concernant l'homologation du plan directeur des routes métropolitaines; 5° D'autoriser la corporation à construire des routes métropolitaines; 6° D'autoriser la corporal ion à construire une Toie, en tout ou en partie souterraine, en vue du transport en commun rapide; 7° D'autoriser la corporation à procéder à une planification métropolitaine; 8° D'obliger toutes les municipalités concernées faire un nouveau rôle d'évaluation pour l'année 1904; 9° D'autoriser la Corporation à réglementer les taxis; 10° De permettre àl a corporation d'adopter un budget supplémentaire au cours de l'année 1901; 11 D'insérer des amendements touchant la perception des amendes; 12° D'augmenter les pénalités pour infractions aux dispositions du règlement concernant les heures d'ouverture et «le fermeture «les établissements commerciaux; 13° De définir les mots «établissements commerciaux »; 14° D'accorder à la corporation tous autres pouvoirs nécessaires pour mieux «lesservir les intérêts de la population «le la région métropolitaine.Montréal, ce lOième jour de janvier 1961.Le Conseiller Juridique de Iax Corporation de Montréal Métropolitain, ( i A HI! I Kl.DUPL'IS, C.R.56287-2-4-Q Dame Robert Poliquin « Dame Robert I'oliquin » donne, par les présentes, avis qu'une pétition sera présentée à la Législature de Québec, à la présente session, pour l'adoption «l'une loi aux fins «le faire disparaître toute servitude de droit de passage ayant pu être établie par destination «lu père de famille sur la subdivision (585-49) devenue par la suite, par resubdivision, les lots numéros (585-49-1-2-3-4) aux plan et livre «le renvoi du cadastre officiel de la paroisse de St-Roch Nord, cité de Québec: Les l'nx'ureurs de la pétitioiuiaife, 56294-3-4-0 Pit, & An.Cokkivkau & Cakon.Collège des ebiroprntieiens de la province de Québec Avis est par les présentes donné, «pie le « Collège «les chiropraticiens «le la province de Québec » demandera à la Législature de la province de Québec, au cours «le la présente session, l'adoption d'une loi pour: a) Constituer en corporation professionnelle le Collège «les chiropraticiens du Québec; b) Définir la chiropraticpie; c) Décréter qui aura le droit «l'exercer cette profession; d) Créer le conseil général de c«'tte corporation; e) Créer le comité «le discipline de cette corporation; /) Établir les pouvoirs de régie de cette profession ; g) Établir les conditions d'admission à l'étude de la chiropratique.Montréal, ce 27 décembre, 1960.Le Procureur de la pétitionnaire, 56295-3-4-0 .Pothier Ferland.Université de Trois-Rivières Son Excellence Monseigneur Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières, Monseigneur 4.To change certain provisions regarding the homologation \"of the master plan of metropolitan roads; 5.To authorize the corporation to build metropolitan roa«ls; 6.To authorize the corporation to build a rapid mass transit system, in whole or in part underground: 7.To authorize the corporation to proceed with planning on a metropolitan basis; 8.To compel all the municipalities concerned to draw a new valuation roll for 1964; 9.To authorize the corporation to régulât-taxis; 10.To permit the corporation to adopt a supplementary budget during 1961; 11.To insert amendments regarding the collection of fines; 12.To increase the penalties for infraction* against the provisions of the by-law regulating the opening and closing hours of commercial establishments; 13.To define the words \"commercial establishments\"; 14.To grant the corporation all other powers required so as to better serve the interests of the population of the metropolitan territory.Montreal, this 10th day of January, 1961.Gabriel Dupuis, q.c, Legal Counsel of The Montreal Metropolitan Corporation.56287-2-4-0 Dame Robert Poliquin \"Dame Robert Poliquin\" hereby gives notice that a request will be presented to the Quebec Legislature, during its present session, ft>r the adoption of an act removing all servitudes of right of way having been established by the father of the family on subdivision (585-49) which later became, through re-subdivisum, the lots number (585-49-1-2-3-4) in the plan ami book of reference of the official cadaster of the parish of St-Roch North, city of Quebec.Ph.& An.Corriveau & Carom, 56294-3-4 Attorneys for the petitioner.Quebec College of Chiropractors Notice is hereby given by the \"Quebec College of Chiropractors\" that it will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session, for the passing of an Act: a) Constituting the professional corporation of the Quebec Chiropractic College; b) Defining the art of chiropractic; c) Decreeing who will have the right to practice this profession; d) Creating the administrative council of this corporation; e) Creating the disciplinary board of this corporation ; /) Establishing the governing powers of this profession ; g) Determining the qualifications to study the art of chiropractic.Montreal, this 27th day of December, 1960.Potiiier Ferland, 56295-3-4-o Attorney for the petitioner.University of Trois-Rivières His Excellency, Monsignor Georges-Léon Pelletier, Bishop of Trois-Rivières, Monsignor Charles- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1001, Vol.03, A'o.3 325 < hurles-Edouard Bourgeois, Monsieur 1c < 'ha Doine Albany Mélaneon, supérieur «lu Séminaire de Trois-Rivières, Monsieur le Chanoine Raymond Lungcvin, supérieur du Séminaire Sainte-Marié «le Shawinigan, Monsieur l'Abbé Renuld Kivard, Monsieur PAbbé Louis Martel, Monsieur l'Abbé Réal Mercier, Monsieur l'Abbé Gilles Boulet, l'Honorable .luge Jean-Louis Marchand, .ICS., Monsieur Henri Perron, C.A., le dr J.A.Denoucourt, Me Léon Luniothe, Me Richard Kioux, Monsieur Léon Gervais ¦'adresseront à la \u2022 égùlature «le Québec lors de sa première session pour être constitué en corporation sous le nom \u2022 le Université de Trois-Rivières, avec siège social aux Trois-Rivières, ayant tous les droits, pouvoirs i ! privilèges «l'une Université y compris le droit de former des facultés, d'accorder des diplômes, d'accepter des affiliations, de posséder toutes sortes «le propriétés et pour tous autres buts; avis public est par les présentes donné de lu nature et des objets «lu bill projeté.Shawinigani ce 12 janvier 1901.Le Procureur, .\")\u2022.>10-3-4»o \u2022 LÉON Lamotiif.Sourp llagop Armenian Church Avis est par les présentes donné que Garabetl S.Parl/.igian, marchand, Gurabcd Mouradian, racommodeur «le tapis, Bedros Kaprielian, poseur ¦ le tapis, Kerop Bedoukian, marchand.Kapricl Kaprielian, chauffeur de taxi, tous domiciliés et tendant dans la cité de Montréal, P.Q., Yervant Savoyan, vendeur, domicilié et résidant à ville Saint-Laurent, P.Q., Serko Boyadjian, bijoutier, domicilié et résidant dans la cité d'Outremont, P.O.et Yervant Pasdermajian, marchand, domicilié et résidant à ville Mont-Royal, P.Q., et uu-l res feront une demande à la présente session de Is législature «le Québec pour l'adoption d'une loi pour constituer en corporation une corporation ecclésiastique sous le nom de « Sourp Hagop Armenian Church » et avec tels pouvoirs qui sont habituellement accordés à une corporation ecclé-BÎastique.Montréal, P.Q., le 17 janvier 1961.Let Procureurs des Requérant*, 'i(iwaui).Cate, Ouilvy, Bishop, Cope, \u2022>353-3-4-o Pokteous & Hanhahu.Fdouurd Bourgeois, the Reverend ( anon Albany Mélaneon, Superior of the Seminury of Trois-Rivières, the Reverend Canon Raymond J .angevin, Superior of the Seminary Suinte-Marie «le Shawinigani Reverend Father Ronald Rivard, Reveraml Father Ixmis Martel, Reverend Father Réal Mercier, Reverend Father Gilles Boulet, the Honouralbe Judge lean-Louis Marchand, S.C.J., Mr.Henri Ferron.C.A., Dr.J.A.Denon-court.Me Léon Lainotlu', Me Richard Rioux, Mr.Léon Gervais will apply to the Legislature of Quebec at its first session to be incorporated Under the name of University of Trois-Rivières, having all the rights, powers ami privileges of a University comprising therein the right to form faculties, grant diplomas, accept affiliations, to own all kinds of properties ami for all other purposes; public notice is hereby given of the nalure and purposes of the projected bill.Shawinignn, January 12, 1961.Lj'.on Lamothe, 56316-3-4 Attorney.Sourp Ilagop Armenian Church Notice is hereby given that Garabetl S.Part-zigiun, merchant, unrobed Mouru«lian, rug repairer, Bedros Kaprielian, carpet layer, Kerop Bedoukian, merchant, Kapriel Kaprielian, taxi driver, all domiciled ami residing in the city of Montreal, P.Q., Yervant Savoyan.salesman, domiciled and residing in the town of ville Saint-Laurent, P.Q., Serko Boyadjian, jeweller, domiciled and residing in the city of Outremont, P.Q., and Yervant Pasdermajian, merchant, domiciled and residing in the town of Mont-Royal, P.Q., and others will apply at the present session of the Quebec Legislature for an Act to incorporate an ecclesiastical corporation under the name of \"Sourp Hagop Armenian Church\" and with such powers as are usually granted to an ecclesiastical corporation.Montreal.P.Q., January 17th.1961.Howard, Cate, OqILVT, BlSHOP, Cope, Porteois & Haxsakd, 56353-3-4-0 Attorneys for Petitioners.Département de l'Instruetion publique N81955-60.Ville de Montmagny Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de la ville de Montmagny, lans le comté de Montmagny, en celui de \u2022 Montmagny », même comté.Québec, le 4 janvier 1961.Le Surintendant de VInstruction publique, \")6206-2-2-o O.-J.Desaulniers.\\TO 627-55.Canton de Granby Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire protestante du canton de Granby, dans le comté de Shefford, les territoires ci-des-*ous décrits, pour les annexer, pour les contribua-Mes protestants seulements, à la municipalité scolaire protestante de la cité de Granby, dans le ruAme comté, savoir: Department of Education No.1955-60.Town of Montmagny Application is made to change the name of the school municipality of the town of Montmagny in the county of Montmagny into that of \"Montmagny\", same county.Quebec, January 4th, 1961.O.-J.Desaulniers, 56206-2-2 Superintetuient of Education.No.627-55.Township of Granby Application is made to detach from the Protestant school municipality of the township of Gianby, in the county of Shefford, the territory described below, in order to annex them, for the benefit of Protestant tax-payers only, to the Protestant school municipality of the city of Granby, in the same county, to wit: 326 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI janvier 1961, Tome 93, N° S 1° « Un territoire, situé dans le canton de Granby, comprenant en référence au cadastre officiel dudit canton, le lot 632 rang VII et une partie du lot 732 rang VIII et dont les limites se décrivent comme suit: à savoir: Partant du point d'intersection de la ligne séparant le lot 732 des lots 735 et 736 du rang VIII avec le côté sud-ouest d'un chemin public (route rurale N° 4); de là, ledit côté sud-ouest dudit chemin public en allant vers le sud-est sur une longueur de 620.3' pieds; puis dans le lot 732 rang VIII une perpendiculaire audit côté sud-ouest dudit chemin public jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 631 et 632 rang VII; ledit prolongement et ladite ligne separative des lots 631 et 632 rang VII; la ligne separative des lots 630 et 632 et la ligne separative des lots 632 et 633 rang VII et enfin ladite ligne séparant le lot 732 des lots 735 et 736 rang VIII jusqu'au point de départ.» 2° « Un territoire, situé dans le canton de Granby, comprenant une partie du lot 726, du cadastre officiel du canton de Granby et dont les limites se décrivent comme suit, à savoir: Partant du point d'intersection de la ligne nord du lot 728 avec la ligne separative .des lots 726 et 727 du cadastre officiel du canton de Granby; de là, en référence au susdit cadastre officiel, successivement, les lignes suivantes; la ligne separative entre les lots 726 et 727 jusqu'au côté sud du chemin public, au nord dudit lot 726; ledit côté sud du chemin public jusqu'à la ligne separative des lots 725 et 726; cette dernière ligne j îsqu'à un point distant de 102' pieds au nord-ouest de la ligne separative des lots 724 et 725, mesurés le long de ladite ligne separative des lots 725 et 726; puis, suivant les limites actuelles de la cité de Granby, dans le lot 726, une ligne parallèle à la ligne separative des lots 724 et 725 sur une longueur approximative de 129%' pieds jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots de subdivision 728-54 et 728-55; ledit prolongement en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 728 et 726 et enfin, ladite ligne separative des lots 728 et 726 en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ ».3° « Un territoire situé dans le canton* de Granby, comprenant, en référence au cadastre officiel dudit canton, les lots ou parties de lots, et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, ruelles, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot de subdivision 718-423; de là, suivant les limites actuelles de la cité de Granby, en passant successivement par les lignes suivantes: la ligne separative' des lots originaires 717 et 718, en allant vers le sud-ouest jusqu'au coin sud du lot de subdivision 718-382; la ligne sud des lots de subdivision 718-382, 718-381 (rue), 718-356, 718-355, 718-354 (rue), 718-341, 718-330, 718-329 \"(rue et 718-317; la\"ligne separative des lots originaires 718 et 179 en allant vers le sud-ouest sur une longueur de 1,295 pieds; une ligne droite traversant le lot originaire 719 et une partie du lot -originaire 720 jusqu'au coin sud du lot de subdivision 720-161; la ligne sud-ouest du lot de subdivision 720-161; la ligne nord-ouest des lots de subdivision 720-161; 720-160, 720-159, 720-158, 720-157, 720-156, 720-155, 720-154 et son prolongement dans le lot originaire 720 jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à la ligne separative des lots 724 et 725 à une distance perpendiculaire de 100 pieds au nord-est d'icelle; ladite ligne parallèle en allant vers le nord-ouest 1.\"A territory, situated in the township of Granby, comprising, with reference to the official cadaster of said township, lot 632 of rang \\ II and a part of lot 732 on range VIII and whose boundaries are described as follows: to wit: Starting at the point of inteisection of the line separating lot 732 from lots 735 and 736 on range VTII with the south-west side of the public road (rural route No.4); thence, said south-west side of said public road going towards the south-east to a distance of 620.3' feet; then, on lot 732.rangs VIII, a line perpendicular to the said south-wt st side of said public road as far as the lengthening of the line separating lot 631 from 632, range VII; said prolongation and said line separating lot 631 from 632.range VII; the line separating lot 630 and 632 and the line separating lot 632 from 633, range VII, ami finally the said hue separating lot 732 from lots 735 and 736 ou range VTII as far as the point of departure.\" 2.\"A territory, situated in the township of Granby, comprising a part of lot 726, in the official cadaster of the township of Granby and whose boundaries are described as follows, to wit: From the point of intcrse< tion of the north line of lot 728 with the separative line between lots 726 and 727 in the official cadaster of the township of Granby; tl.ence, with reference to the above, mentioned official cadaster, successively, the following bound nies: the separative line between lots 726 and 727 as far as the south side of the public road, to the north of lot 726; the said south side of the public roud as fur ; s the line separating lot 725 fr< m 726; the latter boundary as fur us a point 102' feet distant to the northwest of the separative line l)etwcen lots 724 and 725, measuring the lenhgl.of said separative line between lots 725 and 726; then, following the present boundaries of the city of Granby, on lot 726, a line parallel to the line separating lots 724 and 725, to a distance of approximately 129' *' feet us far as the prolongation of the separative line between lots of the .subdivision 728-54 and 728-55; said prolongation going towards the south-west as far as the line separating lots 728 and 726, and finally, the s id line sepaiuting 1 Is 728 and 726 going towards the west to the po d of departure.\" 3.\"A territory situated in the township of Granby, comprising, with reference to the official cadaster of said township, the lots or parts of lots and their present and future subdivisions, as well as the roods, streets, lanes, water ways or parts of thé same enclosed with the following bound ries, to wit: from the top of the north-east ang!< of the lot of subdivision 718-423; thence, follow ing the present boundaries of the city of Granby passing, successively, by the billowing boundar lines; the line separating the original lots 717 ami 718, going towards the south-west as far as the south corner of the lot of subdivision 718-382 the south line of the lots of subdivision 718-382.718-381 (street), 718-356, 718-355, 718-351 (street), 718-341, 718-330, 718-329 (street), an.718-317; the separative line between original lots 718 and 179 going towards the south-west to n distance of 1,295 feet; a straight line crossing tin original lot 719 and a part of original lot 720 a-far as the south corner of the lot of subdivisioi 720-161; the south-west boundary line of the loi of subdivision 720-161; the north-west line of th< lots of the subdivision 720-161 ; 720-160, 720-159 720-158, 720-157, 720-156, 720-155, 720-154 an.its prolongation across original lot 720 as far a its intersection with a line parallel to the sépara tive line between lots 724 and 725 to a perpendi cular distance of 100 feet to the north-east of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1961, Vol.93, No.S 327 jusqu'au coté nord-ouest de la rue Frechette en n n point distant de 14 pieds au nord-ouest de la ligne separative des lots originaires 720 et 725 mesures le long de ladite ligne parallèle; puis, laissant les limites actuelles de la cité de Granby, lans le lot originaire 725, ledit côté nord-ouest de la rue Frechette sur une longueur de 1,600 I lieds jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public en un point distant de 28 pieds de la ligne sépa-lative des lots originaires 720 et 725 mesurés le long dudit côté sud-ouest du chemin public et enfin ledit côté sud-ouest du chemin public en allant vers le sud-est, traversant une partie du lot originaire 725 et les lots originaires 720, 719 et 718 jusqu'au point de départ ».Québec, le 30 décembre 1960.I.r Surintendant de l'Instruction publique, 56189-2-3-0 O.-J.Desaulniers.latter; said parallel line going towards the northwest as far as the north-wist side of Frechette street to a point 14 feet distant to the north-west of the sepal alive line between original lots 720 and 725 measured the length of said parallel line; then, leaving the present boundaries of the city of Granby, on original lot 725, said north-west side of Frechette street to a length of 1,600 feet as far as the south-west side of a public road to a point 28 feet distunt from the line separating original lots 720 and 725 measured the length of said south-west side of the public road and finally the south-west side' of the public road going towards the south-east, crossing a part of original lot 725 and original lots 720, 719 and 718 as far as the point of departure.\" Quebec, December 30, 1960.O.-J.DeBAULMERS, 56189-2-2 Superintendent of Education.Département des Mines Déclaration de révocation Je soussigné, Paul YV.Karl, ministre des Mines de la province de Québec, déclare ce jour évoquer la vente de la concession minière N° 302 pour métaux supérieurs affectant le terrain \u2022 ï-après décrit, pour défaut d'accomplissement des conditions prescrites à l'article 41 des Statuts refondus de la province de Québec 1925 tel iii'amendé par 1 George VI, chapitre 41.article 18, conformément à l'article 49 de la Loi dis \u2022nines de Québec (S.R.Q.194J, chapitre 196).Cette concession minière vendue à Halliwcll '.old Mines Limited, le 22 juillet 1938, couvre le claim T-3805 du canton de Beuuchastel, dis-i rict électoral de Rouyn-Noranda.Québec, le 25 novembre 1960.Lé Ministre des Mines de la province de Québec, Y»326-3-2-o Paul Earl.Department of Mines Declaration of revocation I, the undersigned, Paul W.Earl, Minister of Mines of the Province of Quebec, do this day declare revoked the sale of the mining concession No.302 for superior metals, affecting the land hereafter described by virtue of the failure to comply with the conditions set forth by section 41 of the Revised Statutes of Quebec 19.5 as amended by 1 George VI, chapter 41, section 18, in conformity with section 49 of the Quebec Mining Act (R.S.Q., 1941, chapter 196).This mining concession sold to Halliwell Gold Mines Limited, the 22 of July, 1938, covers the claim No.T-3805 of Reauehastel township, electoral district .pf Rouyn-Noranda.Quebec, November 25, 1900.Paul Earl, Minister of Mines 56326-3-2-0 of the Province of Quebec.Département des Terres et Forêts Avis I adastre officiel de la paroisse de Charlcsbourg, municipalité de ville d'Orsainville, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 107-8, 407-5, 407-6, 407-8 et une partie des lots II 17-2 et 407-9 sont annulés en vertu de l'article '174A du Code civil.Québec, le 10 janvier 1961.Lé Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 56289-0 J.-Édouard Guay.< 'adastre officiel de la ville de Levis, quartier Notre-Dame, municipalité de cité de Lévis, division d'enregistrement de Levis.Avis est par la présente donné que les lots 296-B, 297-A-2, 297-B.297-C, 298, 298-A, 298-B, 298-C et une partie des lots 296, 297 et 297-A sont annulés et le lot 1306 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 16 décembre 1960.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, Ô6289-0 J.-Éoouard Guay.Department of Land,and Forest Notice Official cadastre of the parish of Charlcsbourg, municipality of town of Orsainville, registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 407-3, 407-5, 407-6, 407-8 and a part of lots 407-2 and 407-9 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, January 10, 1961.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-Édouard Guay, 56289-0 Deputy Minister.Official cadastre of the town of Levis, Notre-Dame ward, municipality of city of Levis, 'registration division of Levis.Notice is hereby given that lots 296-B, 297-A-2, 297-B, 297-C, 298, 298-A, 298-B, 298-C and a part of lots 296, 297 and 297-A are cancelled and lot 1306 has been added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, December 16, 1960.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, J.-Édouard Guay, 56289-o Deputy Minister.\" 328 QAZETTË OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1061, Tome 03, N° 3 Cadastre officiel «le la paroisse «le Pointc-uux-Treinblcs, municipalité de ville de Mont ical-Est, «livision d'enregistrement de Montreal.Avis est par la présente donné Que le l«»t 1 -ft\u20141 est annulé en vertu «le l'article 2174A «lu Code civil.Québec, l«- 28 décembre I960.Le Département deê 'terres et Forets, Service du Cadustre, Le Sous-ministre, 50289-o j.-Edouard Guay.Cadastre officiel «le la paroisse «le Saiut-Jouchim de Châteauguay, municipalité «le ville «le Châ- teauguay, division d'enregistrement «le Châteauguay Avis est par lu présente donué «pie les lots 47-122 ù 47-124.4844 à 48-70.49-120 à 49-138 sont annulés en vertu «le l'article 2171A «lu Code civil.Québec, le 19 décembre 1900.Le Département des Terres et Forêts, Service du ( adastre.Le So us - m in ist re, 50289-o J.-Edouard GuAT.Cadastre officiel «le la paroisse de Saint-Sauveur, municipalité de village «le Saint-Sauveur «les Monts, division d'enregistrement «le Terre-bonne Avis est par lu présente donné que les lots 335-68 et 335-69 sont annulés en vertu «le l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 décembre 1960.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 5C289-0 J.-Édolard Guay.Lettres patentes Officiai cadastre Of the parish of Pointe am.Trembles, municipality of town of Montreal-East, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 14-1 has been cancelled in virtue of article 2174 A of the Civil Code.Quebec, December 28, I960.Department of Lands and Forests, Cadastral If ranch, J.-Edocari) Guay, 56280-0 Deputy Minister.Ollieial cadastre of the parish of St .loachini de Châteauguay, municipality of ville of Châteauguay, registration division of Châteauguay Notice is herebv given that lots 47-122 to 47-124.48-64 to 48-70.49-120 to 49-13S .,.< cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec.December 19, 1960.Department of Lands and Forests, Cadastral liranch, J.-Édouard Guar, 66289-0 Deputy-Minister.Official cadastre of the parish of Saint-Sauveur, Municipality of village «>f Saint-Sauveur des Monts, registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that hits 335-68 end 335-69 ure cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil code.Quebec, December 28, 1960.Department of Lands and Forests, Cadastral li ranch, J.-Édouard Guay, 56289-o Deputy-minister.Letters Patent Foyer Saint-Antoine Avis est donné qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la lx>i des évoques catholiques romains, 14 George VI, chapitre 76, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de lu province de Québec, des lettres patentes, en date du 27 décembre 1960, constituant en corporation le a Foyer Saint-Antoine ».Le siège social de la corporation ci-haut mentionnée est situé en la cité de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix-huit janvier 1961.Le Sous-secrétaire de la province, 50359-o Raymond Douvillk.(P.G.10385-00) Madeleine Realty Corp.Correction Dans le titre de l'avis concernant l'émission des lettres patentes, en date du 28 janvier 1960, constituant en corporation la compagnie ci-haut mentionnée \u2014 voir Gazette officielle de Québec, Tome 92, N° 19, du 7 mai 1960, à la page 1987 \u2014 prière de lire s Madeleine » au lieu de f Madclaine », le nom exact de la compagnie se lisant effectivement comme suit: « Madeleine Realty Corp.».56288-0 Foyer Saint-Antoine Notice is given that pursuant to the provisions of article 20 of the Roman Catholic Bishops' Act, 14 George VI, chapter 76, letters patent have been granted by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December 27, 1960, incorporating the \"Foyer Saint-Antoine\".The head office of the above mentioned Corporation is situated in the city of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, the eighteenth day of January, 1961.Raymond Douvillk, 56359 Assistant Secretary of the Province.(A.G.10385-60) Madeleine Realty Corp.Correction In the title of the notice concerning the issue of letters patent, dated January 28, 1960, incorporating the above mentioned company \u2014 see Quebec Official Gazette, Volume 92, No.19, of May 7\", 1960, on page 1987 \u2014 please read \"Madeleine\" in lieu of \"Madelaine\", the exact name «>: the company effectively reading as follows: \"Madeleine Realty Corp.\" 56288 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1901, Vol.93, Ko.3 329 Ministère «les Finances Assurances Indemnity Insurunce Company of North America Irw d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que « Indemnity Insurance Company of North America », dont le siège social est situé à Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, a réassuré toutes ses ufTaires dans lu province de Québec* auprès «le « Insurunce Company of North America », dont le liège social est situé à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique, en vertu «l'un contrat de réassurance inter-¦ enu entre ces deux compagnies le 6 juillet 1900 i t qui a pris effet le 1er janvier 1901 ; Attendu que « Indemnity Insurance Company of North America » s'est conformée aux autres dispositions de l'article 103 «le la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes lionne que le permis et le certificat d'enregistrement de « Indemnity Insurance Company of North America » sont annules ù compter du 4 janvier 1901.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 4 janvier 1961.Pour le Ministre des finances de la prorince.Le Surintendant des assurances, \"'-205-2-2-o Gustave-E.Tremblay.Industrial Mutual Insurance Company dits d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que c Industrial Mutual Insurance » 'ompony », dont le siège social est situé à Itoston.état du Massachusetts, États-Unis o! Amérique, a été fusionnée par « Arkwright Mutual Insurance Company », dont le siège social est situé i Boston, état du Massachusetts, l liits Unis d'Amérique, en vertu d'un acte de fusion intervenu entre ces deux compagnies le 13 juillet 1960 et qui a pris effet le 31 décembre 1000: Attendu que « Industrial Mutual Insurance ' 'ompany » s'est conformée aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances: En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « Industrial Mutual Insurance Company » sont annulés ù compter du 3 janvier 1961.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 3 janvier 1961.Pour le Ministre des finances de la province, Is Surintendant des assurances, Ô6205-2-2-o Gustave-E.Tremblay.The Liverpool-Manitoba Assurance Company Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que « The Liverpool-Manitoba Assurance Company », dont le siège social est situé à Montréal, province de Québec, a été fusionnée par « The Hudson Bay Insurance Company », dont le siège social est situé à Montréal, province de Québec, en vertu d'un contrat de fusion Department of Finance Insurance Indemnity Inxiirunce Compuny of North America Notice of cancellation of licence and registration Whereas \"Indemnity Insurance Company of North America\" whose head office is situate in Philadelphia, Pennsylvania, United States of America, has reinsure*! ull its business in the Province of Quebec with \"Insurance Company of North America\", whose head office is situute iq Philadelphia, Pennsylvania, United States of America, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 6th of July, 1960, and which has taken effect on the 1st of January, 1961 : Whereas \"Indemnity Insurance Company of North America\" has otherwise complie«l with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license und certificate of registration of \"Indemnity Insurance Company of North America\" are cancelled as from the 4th of .January, 1961.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 4th of January, 1961.For the Minister of Finance of the Province, Gustave-E.Tremblay, 56205-2-2-o Superintendent of Insurance.Industrial Mutual Insurance Company ! Notice of cancellation of license and registration Whereas \"Industrial Mutual Insurance Company\", whose head office is situate in Boston, State of Massachusetts, United States of America, has been marged into \"Arkwright Mutual Insurance Company\", whose head office is situate in Boston, State of Massachusetts, United States of America, according to an agreement of merger entered into by these two companies on the 13th of July I960 and which has taken effect on the 31st of December, 1960; Whereas \"Industrial Mutual Insurance Company\" has otherwise complie»! with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Industrial Mutual Insurance Company\" arc cancelled as from the 3rd of January, 1961.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 3rd of January, 1961.For the Minister of Finance of the Province, Gustave-E.Tremblay, 66205-2-2-o Superintendent of Insurance.The Liverpool-Manitoba Assurance Company Notice of cancellation of license and registration Whereas \"The Liverpool-Manitoba Assurance Company\", whose head office is situate in Montr real, Province of Quebec, has been amalgamated into \"The Hudson Bay Insurance Company\", whose head office is situate in Montreal, Province of Quebec, under an amalgamation agree- 330 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 98, N\" 8 en date du 4 octobre 1960 et qui a pris effet le 1er janvier 1961; Attendu que « The Hudson Bay Insurance Company », la corporation subsistante, est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « The Liverpool-Manitoba Assurance Company » s'est conformée aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de « 1 he Liverpool-Manitoba Assurance Company » sont annulés à compter du 3 janvier 1961.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 3 janvier 1961.Pour le Ministre des finances de la province, 1a Surintendant des assurances, 66205-2-2-o Gustave-E.Tremblay.ment dated October 4th, 1960, and that has taken effect on the 1st of January, 1961 ; Whereas \"The Hudson Bay Insurance Com* pany\", a company duly authorized to do busim ,s in this Province, is the resulting corporation; Whereas \"The Liverpool-Manitoba Assurai es Company\" has otherwise complied with (lie provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that 1'ie license and certificate of registration of \"The Liverpool-Manitoba Assurance Company\" are cancelled as from the 3rd of January, 1961.(liven at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, on the 3rd of .la m m , 1961.For the Minister of Finance of the Province, Gustave-E.Tremblay, 56205-2-2-o Superintendent of Insurance The I-on do n and Provincial Marine and General Insurance Company Limited Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que s The London and Provincial Marine and General Insurance Company Limited », dont le siège soeiul est situé à I^ondres, Angleterre, a rérssuré toutes ses affaires dans lu province de Québec auprès de « The Yorkshire Insurance G mpany Limited », dont le siège social est situé à York, Angleterre, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 15 décembre I960 et qui a pris effet le 31 décembre 1960; Attendu que « The London and Provincial Marine and General Insurance Company Limited », s'est conformée aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi êtes assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « The London and Provincial Marine and General Insurance Company Limited » sont annulés à compter du 3 janvier 1961.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 3 janvier 1961.Pour le Ministre des finances de la pronnee.Le Surintendant des assurances, 66205-2-2-o Gustave-E.Tremblay.The London and Provincial Marine and General Insurance Company Limited Notice of Cancellation of license and registration Whereas \"The London and Provincial Mar .e and General Insurance Company Limited\" whose head office is situate in London, England, has reinsured all its business in the Province of Quebec with \"The Yorkshire Insurance Company Limited\", whose head office is situate in York, England, according to a reinsurance agi< Public notice is hereby given by the under-signed J.-Léo Beaudet, secretary-treasurer of the corporation of the county of Two-Mountains that THURSDAY, the NINTH of MARCH 1 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 93, N\" 3 342 mil neuf cent soixante et un, à DIX heures de l'avant-midi en la salle municipale du comte des Deux-Montagnes, à Ste-Scholustiquc, les immeuble-, suivants seront vendus ù l'enchère publique pour taxes municipales et scolaires dues sur chacun de ces immeubles à moins (pie ces taxes ne soient acquittée! avec les frais encourus avant la vente savoir: nineteen hundred and sixty-one at TEN o'clock in the forenoon in the Hall of the county of Two-Mountains at Ste-Scholastique, the following immoveable property will be sold at public auction for municipal and school taxes due on each of the same lots unless those taxes together with the costs incurred up be paid before the Bale to wit: Paroisse de Suint-Benoit - Pariah of Saint-Benoit Nom Name\tAdresse Address\tN° du lot et du cadastre Lot and cadastral No.\tMontant dù Amount due \t\tP.304.\t8 30.19 \t\t\t Village de Saint-Benoit - Village, of Saint-Benoit\t\t\t \t\tP.303.\tS 168 08 \t\t\t Municipalité «l'Oka \u2014 Municipality of Oka\t\t\t \tOka, Que., Ste-Catherine.\t105-121-130.30 P.\tS 0.72 1,025.11 52 22 202.72 Total____ 81 ,280 77 101.38 51 33 33.40 Total____ 2li, 11 Chené, Pierre.\tAnnonciation.\t27-20 P.\t Patterson.\\V.P.et-and Mine-Mrs , 5, rue-street Burton.Westmount, Montréal.Fafard.Lui Hull, forming part of lot number twenty-seven in the twelfth range of the primitive subdivision of Perkins, hounded towards the east by the lot 20-A, towards the south by number 27B, towards west by lot 28, having 26 chains 22 links in front by 46 chains in depth forming 120 acres, 2 roods and 17 perches and a half in superficie.Lot number 27B.Lot number twenty-seven B in the twefth range, township of Perkins, county of Hull, forming part of lot number twenty-seven B in the twelfth range, of the primitive division of Templeton.bounded towards the north by lot 27A, towards east by lot 26B towards the outh by the division line between range 12 and 11, towards the west by loi number 28 having 20 chains and 22 links in front by 46 chains in depth forming 120 acres, 2 roods and 17 porches and half in superficie and with possession to In-accounted from to-day.Mario et-and Peter Kurpita 230 acres lot 28.12.28.70 5.89 34.5!» Lot numéro 28.Le lot numéro vingt-huit, dans le douzième rang, canton de Perkins, comté de Hull, étant de forme irrégulière et borné vers le nord par un lac et la ligne separative entre les rangs 12 et 13, vers l'est par le lot 27-A et 27-B, vers le sud par la ligne separative entre les rangs 12 et 11, vers l'ouest par un lac et le canton de Wakefiejd, contenant deux cent trente acres (230) de superficie.Lot number 28.Lot number twenty-eight, in the twelve range, township of Perkins, county of Hull, being of irregular figure bounded towards the north by Lake and the division line between ranges 12 and 13 towards the east by lot number 27A and 27B.towards the south by the division line between range 12 and 11, towards the west by a Lake and the township of Wakefield, containing two hundred and thirty (230) acres in superficie.Municipalité de Templeton Ouest (canton de Templeton) Municipality of Templeton West (township of Templeton) Brunet Ernest.Charette, Ferdinand Brousseau-Henri.Gravelle, Emile.Lyrette, Aurèle.Marengere, René.50 x 100 P.50 Gad.-Gat.Ferme-Farm, 50 acres S.E.p.19B.50 x 100 P.50 Gad.-Gat.100 x 100 (23A-9, No 0.).60 x 100 Pt.56 Gad.-Gat.50 x 100 Pt.56 Gad.-Gat.S 30.80 S 58.80 98.33 74.10 10.80 78.66 79.80 S 2.31 6.81 4.05 1.00 4.28 4.34 S 61.11 18694 78.15 11.80 82.D .84.1 i QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21st, 1961, Vol.93, No.S 347 M1111iieds (45'), de là à l'angle droit vers l'est suivant lu imite nord de la propriété dudit Cecil Chamberlain, une distance ^e quatre-vingt-quatre pieds (84') au point de d(part; lo tout borné comme suit: au nord par une autre partie du mémo lot, la propriété d'un dénommé H.G.Carruthcrs, au sud par la propriété dudit Cecil Chambctlain tel que référé plus haut, à l'est pur une partie du môme lot, la propriété de l'acheteur, à l'ouest par la propriété dudit Normad Earley.La propriété présentement vendue est sujette à un chemin do passage de quinze pieds (15') fie largeur sur la portion ouest dudit emplacement présentement vendu et ledit chemin de passage s'étcndnnt de la grande route de Gatineau jusqu'à la continuation de la limite nord dudit emplacement présentement vendu, et ledit chemin borné comme suit: à l'ouest par la propriété dudit Normad Karley; au sud par la continuation de la limite nord de l'emplacement dudit Cecil Chamberlain; au nord par une autre portion du même lot, la propriété du vendeur ou ayant droit, à l'est par le résidu dudit emplacement présentement vendu.Et l'usage dudit chemin pour être en commun par l'acheteur, ses successeurs, héritière et ayants droit, ensemble avec tous les nutres parties intéressées.Moins les parties dudit lot 26A, vendues par Samuel G.Anderson à: n) Cecil Chamberlain par vente enregistrée sous le numéro 34918: b) Le Département do la Voirie par vente enregistrée sous le numéro 37532: «.) George Montgomery par vente enregistrée sous le numéro 60693: Un immeuble situé dans le canton d'Aylwin, comté de Gatineau, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant formée par une partie du lot numéro vingt et peut-être une partie du lot dix-neuf (P.19) tous deux dans le cinquième rang du canton d'Aylwin ci-avant nommé selon les plan et livre de renvoi officiels dudit canton, et ledit morceau de terrain plus particulièrement décrit comme suit: Commençant à un point sur le côté nord-est de la grande route Gatineau dans lo village de Kazabazua et ledit point correspondant au coin sud-est do la propriété de la Commission des Écoles Publiques et ledit point indiqué par un poteau de cèdre; dudit point, à l'anglo droit avoo la grande route de Gatineau ci-avant Rang Range Taxes munie.Munie, taxes S 58.39 Taxes scol.School tuxes 8102.00 Tot:.! S 100 m-ly 'lie tho ud \u2022r->ed rty \u2022re-ist i ti- the All that property known and designated as I» formed of part of lot twenty-six A (P.26A) in the I range of the townslup of Aylmwin, county of Gatint Province of Quebec, and said parcel of land me ism thirty fcet more or less in the westerly line r.n the ( ; n eau Highway; thirty feet more or less in the rear ! parallel to the said (latine m Highway; one bund feet, more or less, on tho north line and one bund feet more or loss on the south lino, with all the build thereon erected, and said parcel of laud bounded follows: Westerly by the Gatineau Highway; north, by another part of the same lot the property of donee; easterly by another part of the same lot, property of Mrs.James Copeland, or part thereof, southerly by another part of the same lot, the pro] ty of the donor.The south line of the above dose: il property being parallel to the south line of the prop of the donee and at thirty feet more or less, south th of.Iron posts are actually planted at tbe souht-c»rner and at the south-west corner of the prop, presently donuted.All that property known and designated us L ; ig that parcel of land formed of part of the nun er twenty-six A (Pt.26A) in the fifth range of the (\u2022 a-ship of Aylwin, according to the official plan und h >k of reference of the said township, and said purer' .if land being more particular, described as follows: Commencing at the northeast corner of the eiiq lacement of Cecil Chamberlain, as purchased from vendor under deed, of sale executed under nui 24288 of the repertory of the undersigned notary, and from that point at right angle towards the north, a distance of forty-five feet (45') thence at right a1 gle towards the west, a distance of eightv-fo-ir feet (84'J to the easterly lino of the property of Normad Barley; thence towards the south following the easterly line of the property of s lid Normad E irley.a distance of forty-five feet (45') thrnce at right angle towards tho east following the northerly limit of the property of said Cecil Chamberlain, a dist nee of eighty-four feet (84') to the point of beginning; the whole bounded as follows: northerly by another part of the same lot.the-property of one named H.C.Cirruthers.southerly by the property of said Cecil Chtmberlaia as above referred to, easterly by another part of the same lot, the property of the purchise-, wastorly bv the property of said Normad Earlev.The property presently sold is subject to a rood way of fifteen feet (15') wide on the westerly portion of said emplacement presently sold and said rood way extending from tho Main Gatineau Highway up to the continuation of Hie northerly limit of said emplacement presently Bold, and said roadway bounded as follows: westerly by the property of said Normad Ewlev; southerly by the cantinu-tion of the northerly limit of the emplacement of said Cecil Chamberlain; northerly bv ano'her portion of the same lot, the property of the vendor of assigns, eisterly by tbe* residue of said emplacement presently sold.And tho use of the said roadway to be in common by the purchaser, his successors, heirs and assigns, together with all other interested parties.Less parts of said lot 26A, sold by Samuel G.Anderson to: a) Cecil Chamberlain by sale registered under number 34918: b) The Department of Highways by sole registered under number 37532: c) To George Montgomery by sale registered under number 50693: An immoveable situated in the township of Aylwin, county of Gatineau, Province of Quebec, consisting n all that property known and designated as beihn Morehead.Thomas Grace, Henry Prestley, S.B.Hodgins, R.F.Simpson, W.J.Wiggins and Erode; k Day and presently fenced-in; with all the buildings thereon erected.Save and except the \u2022 arts Bold by - deeds duly registered as follows: a) part of lot twenty-three, range six and part of lot twenty-three, range seventh-of the said township of Aylwin, registered ut the registry eff ce, Gatireau division, under rrn ! or 3807; 6) part of let twenty-three, range six.of :he township of Aylwin, registered at the registry of ce, Gatineau division, under number 21655; c) part of lots numbers twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twentyeaovan, and twenty-eight, ranee is, township of Aylwin.registered at the registry office of the Gatineau division, under number 30400; d) part of lot twenty-three, ringe six.township of Aylwin, registered at the registrv office of the G itineau di vision, under, number 30731 ; e) part of lots numl era twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven and twenty-eight, range six, township d Aylwin, registered at the registry office of the Gatineau division, under number 32628.s 120 S 08.87 8 70 07 All that property known and designated as being lot number twenty-three (23) in the eighth range of the township of Aylwin, county of Gatineau, Provin e of Quebec according to the official plan and book of reference of the said township with buildings thereon erected to be excluded from the above lot: a) part sold to Mrs.David Little, containing aboit three acres on the lake; b) part sold to Mr.Small, measuring about one acre on the lake; the whole as por deeds duly registered.All that property known and designated as being formed of lot number twenty-three (Pt.23) in the eight range of the township of Avlwin, countv of Gatineau, Province of Quebec, according to the official plan and book of reference of the said-township, containing one square acre of land in superficies, more or less and said one square acre of land bounded as follows: easterly in front by Anderson Lake; northerly and westerly by other parts of the same lot, the pr»- Eerty of Ephrem Anderson or his assigns, southerly y other part of the some lot, the property of Ephrem Anderson or his assigns; together with all buildings thereon erected, with all the members and appurte- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January Slat, 1961, Vol.93, No.3 367 a vac tous lo* droits do passage pour véhicules et autres, à travers le résidu du même lot pour communiquer du inoroCOVI do terrain présentement vendu nu chemin principal, on commun avec toutes les autres parties intéressées; avec tous les membres et appartenances y appartenant.Moins la partie vendue à Raoul Lamoureux par vente enregistrée sous le numéro 39737.Tout ce morceau ou partio de terrain formant une partie du lot vingt-six A (Pt.20A) dans le cinquième rang du canton d'Aylwin, moins et excepté ces morceaux «t parties do terrain vendus par la partie de premièro part antérieurement a la date du présent acte de vente.Indite propriété étant sur le côté nord de la routo do C itineau.Moins les parties vendues à: a) Dame Lloyd Thayer par vente enregistré sous le numéro 19188; b) La Municipalité seoluiro d'Aylwin.par vente enregistrée sous le numéro 29302; c) Parties vendues à la municipalité scolaire d'Aylwin par vente enregistrée sous lo numéro 30381; d) Partie vendue à Allan Little par vente enregistrée sous le numéro 31328; c) Partie vendue à Donald Begley par vente enregistrée sous le numéro 10790.nances thereunto belonging together with all rights of way for vehicles and otherwise, through the residue of tho same lot to communicate from the parcel of land presently sold to tho main road, in common with all other interested parties; with all the members and appurtenances thereunto belonging.Less part sold to Itaoul Lamouroux by sale registered under number 39737.All that part of parcel of land forming part of lot twenty-six A (Pt.20A) in tho fifth range of the township of Aylwin, saving and exception those parcels and parts of land sold bv the party of tho first part prior to tho date of this present deed of sale, said property being on the north side of Gatineau Road.Less part sold to: a) Dame Llovd Thayer by sale registered utider number 19188; b) Tho school municipality of Aylwin.bv sale registered under number 20302; c) parts sold to the school municipality of Aylwin by sale registered under number 30381; d) part sold to Allan Little by sale registered under number 31328; e) part sold to Donald Bogley by sale registered under number 40790.Corporation municipale d'Aylwin \u2014 Canton d'Avlwin (suite) Municipal corporation of Aylwin \u2014 Town«hip of Avlwin (continued) Noms Names\tLoti\tRang Range\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal *\u2022 -cession-Estate, Milford, Gordon.Partie du lot 22, rang 0 et bâtisse des-.S1 î-cession-Estato, Erwin, James H.\tP.22.us.Pa 37, 38, 39.\t0.rt lot 22, range 0 an< 8.\t% .00 1 building s 28.23\t% 90.45 thereon.8124.00\tS 91.05 % 152.29 Lots 37, 38.39, rang S, et bâtisses dessus.Lots 37, 38, 39, range 8, and buildings thereon.Municipalité de Hincks \u2014 Canton de Hincks \u2014 Municipality of Hincks \u2014 Township of Hincks 1 veillé.J.-Bto.I P.30A.Partie du lot numéro 30-A rang 4, canton de Hincks, csurant 110 pieds (110') do front par 148 pieds (148'j le profondeur, le tout plus ou moins, et bornée comme mit: à l'est par le chemin public et des autres côtés par le résidu dudit lot, circonstances et dépendances.Partie du lot numéro 30A.rang 4, canton de Hincks, mesurant 80 pieds de largeur ayant front sur le chemin public, 80 pieds de largeur dans la ligne est.parl48 pieds de profondeur, le tout plus ou moins et borné \u2022onime suit: à l'ouest parie chemin public, au sud par une autre partie du mémo lot, propriété de Joseph Joly, au nord par une autre partie du même lot, propriété d'Edouard Barbe ou représentants, à l'est par une autre partie du môme lot, propriété de Dame F.Dubeau.Avec bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Partie du lot numéro 30A, rang 4, canton de Hincks, plus particulièrement décrite comme suit: commençant au point d'intersection de la limite est de la propriété de François Lé veil lé, telle que décrite dans une vente enregistrée au bureau d'enregistrement de Gatineau sous le numéro 28881, avec la limite nord du chemin privé longeant le lac Ste-Marie, à cet endroit; de ce point de commencement dans une.direction nord, longeant la limite est de la propriété dudit François Léveillé, ci-dessus référée une distance ce 148 pieds jusqu'au coin nord-efct de la propriété dudit ft-ançois Léveillé, ci-dessus référée; de ce point, approximativement a angle droit dans une direction est, une distance de 50 pieds jusqu'à un point; de ce point approximativement à angle droit dans direction sud, une distance de 148 pieds, jusqu'à un point sur le côté nord dudit chemin privé longeant lo lac Ste-Marie à cet endroit; de ce point, à angle droit, dans une direction ouest, longeant la limite dudit chemin privé ci-haut référé, une distance de 50 pieds jusqu'au point de commencement; le tout mesure anglaise est plus ou moins.Ledit '¦\u2022placement borné comme suit; à l'ouest par une autre partie du même lot, propriété de François Léveillé ' i-haut référée, au nord par une autre partie du même lot, propriété de Dame Eva Laramée-Dubeau, à l'est par une autre partio du même lot actuellement occupée par Yvon Knight, au sud par une autre partie du môme lot étant le chemin privé ci-dessus référé.Avec toutes les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Incluant lo droit de puiser de l'eau au puits actuellement existant, en commun, avec ledit Yvan Knight, avec et ujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.I 4.'S 23.10 |t 45.31 |s 68.41 Part of lot number 30-A range 4, township of Hincks, measuring 110 feet (110') in frontage bv 148 feet (148') in depth, the whole more or less, and bounded as follows: on the east, by the public road and on the other sides by the residue of the said lot, circumstances and dependencies.Part of lot number 30A, range 4, township of Hincks, measuring 80 feet in width having frontage on the public road.80 feet in width in tho east line, bv 148 feet in depth, the whole more or less and bounded as follows: on the west by the public roid, on the south by another part of the same lot, property of Joseph Joly, on the north by another part of tho same lot, property of Édou \\rd Barbe or representatives.\" on tho east by another part of the same lot, property of Dame F.Dubeau.With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Part of lot number 30A.range 4, township of Hincks, more especially described as follows: starting at the point of intersection of the evst limits of the property of François Léveillé.as de scribed in a registered sale at the registry office, of G itineau under the number 28881.with the north limit of the private roid running along Lake Ste-Marie, at this place; from this starting point in a northerly direction, running along the east limit of the property of the said François Léveillé, obovo referred to, for a distance of 148 feet to the northeast corner of the property of the said François Léveillé, above referred to; from this point, approximately by a straight angle in an easterly direction, for a distance cf 50 feet to a point; from this point at an approximately right angle in a southerly direction, for a distance of 148 fcet, to a point on the north side of the said private road running along Lake Ste-Marie at this point; from this point, at a right angle, in 8 westerly direction, running along the limit of the said private road referred to above, for a distance, of 60 feet to tho starting point; the whole English measure is more or less.The said emplacement bounded aa follows: on the west by another part of the same lot, property of François Léveillé above referred to, on the north by a other part of the same lot, property of Dame Eva Laramée-Dubeau, on the east by another Sart of the same lot presently occupied by Yvan >iight, on the south by another part of the same lot being the private road above referred to.With all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Including the right of drawing water from the well now in existence, in common with the said Yvan Knight, with and subject to all the servitudes active and passive, apparent and unapparent attached to the said immbveable. 308 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tome 98, N° 8 Incluant conjointement avec toutos autres parties intéressées l'usage d'un chemin privé d'une largeur d'au moins 25 pieds, tel que actuellement utilisé pour véhicule*, ou autrement, lequel chemin privé longeant le lac Ste-Marie a cet endroit et lequel chemin privé communiquant au grand chemin ou rue Principale du village dtl lue Ste-Marie jusqu'à remplacement présentement vendu; servitude perpétuelle étant créée à cette fin en faveur do remplacement présentement vendu contre le résidu dudit lot, tel que le tout est plus au long décrit dans une vente enregistrée sous le N° 80190.Including jointly with all the other partios interested the uso of a private roid of at least 28 foot in width, such as aro presently used for vehicles, or otherwise, which private road runs along Lake Sto-M irio at this place and which road communicates with tho main road or Principal Street of the village of Lake Stc- » Marie to tho emplacement presently sold; perpetual servitude being created for this purpose in favor -if the emplacement presently sold against tho residue of the s iid lot, as the whole is described at a greater length in a sale registered under No.30100.Municipalité de Hincks \u2014 Canton do Hinks (suite) \u2014 Municipality of Hinks \u2014 Township of Hinks (continuett) Noms Names I/Ots D'Aoust, Charles.34.Partie du lot numéro 34, ring 4, canton do Hincks, mosunnt 120 pieds do largeur le long d'un chemin privé conduis int à la route nationale sur 136 pieds de profondeur, plus ou moins, soit la profondeur entre ledit chemin privé et le lac Ste-Marie; bornée vers le nord-ouest par une partie dudit lot vendu par Wilfrid Proulx à Gordon Scintcrbury, par un acte «le vente enregistré au bureau d'ehrogistrenient de Gatine&U sous le N° 10719, vers lo nord-est par ledit lie Ste-Marie, vers lo sud-est par une partio dudit lot 34.la propriété do Alcxina Legault, ou ayants droit, et vers le sud-ouest par ledit chemin privé, avec toute bâtisse dessus érigée.Crass Krank.I 10 .A.Avec bâtisses y érigées enregistré sous le N° 53832.Hang Range Taxes munie.Munie, taxes Taxes sod.Sch .ol taxée Tola 4.$ 27.33 | 55.14 $ 82.17 Part of lot number 34, range 4, township of Hincks, measuring 120 feet in width along a private road, leading to the puhlic road by 188 feet, more or less, depth or the depth between siid private road and Lake Ste-Marie; bounded towards the northwest by pin said lot sold by Wilfred Proulx to Gordon Se mtcrbury.by deed of sale registered in the Gatineau regit office under No.10719, towards the northeast by said Lake Ste-Marie, towards the southeast by part said lot 34.the property of Alcxiuu Legault, or assis and towards the southwest by the said private road, with all building thereon erected.I 3.|$ 27.33 ?65.14 |S 83.41 With buildings therein erecte 1 un 1er No.5283.'.La municipalité scolaire de Maniwnki \u2014 Cunton Kgan School municipality of Muniwaki \u2014 Township of IOgan Dallai re Lambert, Augustin Hubert et-and André-Gérald Nault.P.1-A.Une maison, d'un genre bungdow, satis fondation, partie en birdeiux de cèdre et partio en pl mehe murale, bâtie et érigée sur une p irtie du lot numéro un ¦ A S (Pt l-A) du deuxième rang du canton d'Kgin.8 36.20 3 86.20 A house, bungdow typo, without found it ion, partly in cedar shingles and partly in wdl-boird.built and erected on a pirt of lot number one \"A\" (Pt.1-A) in the second range of tho township of ISgin.ï?onné à Maniwaki, ce cinquième jour du mois de janvier, mil neuf cent soixante et un.Le Secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Gatineau, Mme Palma Joanis.CP.118, Maniwaki.Que.56322-3-2-o Given at Maniwaki, this fifth day of the month of January, one thousand nine hundred and sixty-one.Mrs.Palma Joanis, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Gatineau.P.O.B.118, Maniwaki, Que.56322-3-2 Municipalité du comté de Portneuf Avis public est par les présentes donne par le soussigné, Alfred Naud, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Portneuf, que, JEUDI, le NEUVIEME jour du moisdeMARS mil neuf cent soixante et un ù Cap Santé, à DIX heures de l'avant-midi, à la salle d'audience du conseil, les terrains ci-après décrits seront vendus pour taxes municipales et scolaires et charges auxquelles ils seront affectés, à moins qu'elles ne soient payées, avec les frais, savoir; Municipalité de Saint-Raymond paroisse Comme appartenant à .1.-Rosaire Germain, le lot N° 716 et parties du lot N° 717 décrites dans un acte enregistré sous le N° 114911, moins les parties vendues, une partie du lot N° 741 décrite dans un acte enregistré sous le N° 135269, une partie du lot N° 644 décrite dans un acte enregistré sous le N° 127524, moins les parties vendues, une partie du lot N° 733 décrite dans un ac- Municipality of the county of Portneuf Public notice is hereby given by the undersigned, Alfred Naud, secretary-treasurer of tin-municipal council for the county of Portneuf.that, THURSDAY, the NINTH day of the month of MARCH, one thousand nine hundred and sixty-one, at Cap Santé, at TEN o'clock in the forenoon, in the sitting room of the council, the lands hereinafter described will be sold by auction for the municipal and school taxes and other charges to which they will be liable, unless the same be paid, with costs to wit: Municipality of the parish of Saint-Raymond As belonging to J.-Rosaire Germain, the lot No.716 end parts of the lot No.717 described in a deed registered under No.114911, less parts sold, a part of the lot No.741 described in a deed registered under No.135269, a part of the lot No.644 described in a deed registered under No.127524, less parts sold, a part of the lot No.733 described in a deed registered under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 21if, 1061, 1^/.03, No.8 369 te enregistré sous N° i30753, 'le lot N° 752 moins les parties vendues et parties «les lots Nos 711, 705 et 744 décrites -dans un acte enregistré y,us le N° 140915, moins les purties vendues et et le lot N° 738, moins lu partie vendue ù Marvel Granite Inc.le tout du cadastre officie) pour lu paroisse de Saint-Raymond, 'i axes ducs : $205.83.Connue appartenant à .l.-ltosairç Germain, ou Marvel (iranitc Inc.les lots Nos 739 et 710 du cadastre officiel pour la paroisse de Suint-Ray -inond.Taxes ducs: $105.85.Municipalité du village «le Portneuf ( 'oininc appurtenant à Laurcttc Wcill»renncr, ou Augustine' Weilbrenner, le lot X° 39 du cadastre officiel pour lu paroisse de Notre-Dame de Portneuf, avec bâtisses.Taxes dues: $117.95.Municipalité de Saint - lia si le Comme appartenant à la succession de Arthur-,1.Paqueti une partie du lot N' 1S7 du caar la propriété de Jacques Frenette, au sud par le chemin public à l'ouest par la propriété de Philippe Frenette et au nord par le lot N° 217, environ \\i d'arpent en super-licic.Taxes dues: $41.50.( '(immc appartenant à Henri Denis, une partie ù le Conseil municipal dudit conté lit ut ses sessions.IF.I'DI, le NEUVIÈME jour du moid de MARS, 1901.ù DIX beurei «le l'avant iniili.pour défaut «!«\u2022 paiement dos taxes municipales 11 scolaires el aulns charges dues aux corporations locales ci-api es men-Uonnéeï, à moins que lesdites taxes, avec les frais ne soient payées avant la veille.Municipalité de Saint-Félix, Cap-Rouge Comme appartenant à Dame Thontai Allanl.\u2014 Partie nord «lu loi 84 «lu cadastre int-Amhroisc, mesurant un arp ut et «lenu «le largeur sur environ sept utpents «le profondeur, borné au sii«l par le chemin public, uu nord par Arthur Paradis ou représentants au sud-ouest par Edmond Falar-deau ou représentants «1 partie «lu hit (700) sept cent soixante-six «lu cadastre de Saint-Ambroise, mesurant un arpent et demi de largeur sur lu profondeur comprise entre le chemin public au nord «d le lot 750 au sud, borné au sud-ouest par Roger PalardeaU OU représentants au nord-est par Alphonse Martel ou représentants.Taxes municipales: $31.95; taxes scolaires: $30.00.Total: $02.55.Comme appartenant à Henri Paul Rohilaillc.\u2014 Partie du hit (772) sept cent soixuntc-douzc «lu cadastre pour la paioisse «le* Saint-Ambre»ise, mesurant trois cpiarts «l'arpent «le largeur, borné au su«i par le chemin public, au nord par partie du lot 772 à (100') œnt pieds de la maison au sini-ouest pur Marcel I*:garé ou représentants, au nord-est par Guido Pragasso ou représentants, avec bâtisses.Taxes municipales: $97.94.Total: $97.94.lie solel by public unction, in the Centre paroissial, *in the town of Lorcttcvillt», where the sittings of the Municipal Council of the said county are holel.TH1 RSI )A Y the NINTH day of the month of MARCH.1961, at TEN o'clock.In the forenoon, l'or elefault of payment of municipal and school taxes ami either charges due to the local corporation hereinafter mentioned, unless the said taxes and costs be paid before the sale.Municipality of Saint-Félix, Cap-Rouge As belonging to Mrs Thomas A Hard, north part of lot 84 of the cadastre for the parish of Saint-Félix of Cap-Rouge, ineusuring (25') twenty-five met in depth from the north line, by the width of the lot.Municipal taxes: $1.46; school taxes: 13.98.Total: $5.44.As belonging to Pii'rre Collin estate, part of lot number (52) fifty-two «>f the cadastre for the parish e»f Saint-Félix of Cap Rouge', measuring fifty-live feet in depth from the south line by the width of the lot.Municipal taxes: $2.01; school taxes: $0.55.Total: $9.10.Corporation of Saint-Ambroise As belonging to Leopold Lemelin.\u2014 Part of lot (IKiS) one thousand one hundreel und sixty-eight eif the cadastra for the parish of Saint-Ambroise.bounded to the south by the National Railway to the north by Adrien Vachon.to the southwest by lot 1109 and to the northeast by lot 1107, with buildings.Municipal taxes: $38.90; school taxes: $78.33.Total: $117.2» As belonging to Alphonse Allison.\u2014 The lots 708-10 et 17 sixteen and seventeen of the sul(division of lot seven hundred and sixty-eight and (70!.'-70) seventy e>f the subelivision of lot seven hundred and sixty-nine e>f the cadastre for the parish of Saint-Ambroise.Municipal taxes: SI 1.90; school taxes: $13.79.Total: $25 75.As belonging to Roland Allison.\u2014 The lots No.(708-24 ami 25) twenty-four and twenty-five of the subdivision of lot seven hundred and sixty-eight ami (709-17) seventeen of the subdivision of lot seven hundred and sixty-nine of the cadastre for the parish of Saint-Ambreiise.Municipal taxes: $11.90; school taxes: $20 71.Total: $32.09.As belonging to Guido Fragasso.\u2014 Part eif i.'t (772) six hunelred and seventy-two «>f the cadastre for the parish eif S.iint-Ainbmisc, measuring one parpent and a hall' in wi«fth by about seven urpents in depth, bounded to the south by the public reiaef, to the north by Arthur Paradis or représentatives, to the southwest by Edmond Fulurdeuu or representatives, ami part eif lot (700) seven hundred and sixty-six eif the cadastre for the parish of Saint-Am!iroi.se, meusuring one urpent and a half in width included between the public roa«l on the north side*, ami lot 750 on the south side, bounded to the southwest by Roger Fulurdeuu or re'presentatifes to the northeast by Alphonse Martel eir representatives.Municipal taxes: S31.95; school tuxes: $30.00.Total: $02.55.As belonging to Henri Paul Rol.itaille.\u2014 Part of lot (772) seven hundred an«l seventy-two of the cadastre for the parish of Saint-Ambroise, measuring three quarters of an arpent in width, hounded to the south by the public.road on the north by part of lot 772 at (100') one hundred feet from the house, on the southwest by Marcel Légaré or representatives, on the northeast by Guieio Fragasso or representatives, with buildings.Municipal taxes: $97.94.Total: 897.94. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January gist, 1961, Vol.93, No.3 373 Comme appartenant à Lucien Morin.\u2014 Partie du jot (7Ô7-A) sept cent soixante-sept A du cadastre pour la paroisse de Saint-Aml>roisc, mesurant (100') cent piods de largeur sur (150*) cent cinquante pieds de profondeur, borné au nord-ot par IB chemin public, au nord par le lot 778, au llld et au sud-nlust par le résidu du loi 707A, uvee bâtisses.Taxea municipal»s: $71.1 I; laves scolaires: 857.89.Total: 1131.58.Comme appartenant A Dame Jean EL Beau-lieu.Partie «lu lot (472) «plâtre c*iit soixante-douse «lia cadastre pour !a paroisse «le Saint- Ambroise, mesurant (HK)') cent pieds de largeur par (I!)!)') cent quatre-vingt-dix pieds de proton-d» u1 -, borné au nord-rst pur la rue Cook, uu sud-oui \u2022! par le lot N'° 4S2, au non! par la suce ssion Jam i P.Moore, au sud pur Paul II.Parent, svec bâtisses.-Taxes municipales: $21.(19.To-tsl: 124.60.Comme appartenant à Transport Couture In»-.La lot M8 (574) cinq cent soixante-qua- toiv.\u2022 t two hundred ans sixty-nine, (2G9-S-9-10-11-12-13-14-15-28) eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fouiteen, fifteen ami twenty-eight of the subdivision of lot two hundre I and sixty-nine and a port non subdivided of lot 26.) of the cadastre of Saint-Ambroise.Municipal taxi's: $589.93.school taxes: $383.86.Total: $973.79.Municipality of Saint Dunstan, Lac Beauport As belonging to Gaston Allard.\u2014 The lot (94-12) twelve of the subdivision of lot ninety-four of the cadastre f«ir Saint Dunstan.Municipal taxes: S45.57.Total: $45.57.As belonging to Gaston Allard.\u2014 The lot (94-25) twenty-five of the subdivision of lot ninety-lour of the ca«lastrc of Saint Dunstan.Municipal taxes: $141.37.Total: $141.37.As belonging to Corporation Immobilière Belie Vue \u2014 The lot (49-2) two of tlic subdivision of lot fourty-ninc oi the cadastre of Saint Dunstan.Municipal taxes : S9.02.Total : $9.02.As belonging to Adrien Côté.\u2014 Part of lot (90) ninety of the cadastre of Saint Dunstan, bounded to the northwest by the lake, to the northeast by Elzéar Paquet to the southeast by the public road, to the southwest by J.T.Berrichon.Municipal taxes: $43.45; school tuxes: $16.00.Total: $59:45.As belonging to Mrs Jacques Lomictix.\u2014 Part of lot (53) fifty three of the cailastre of Saint Dunstan.bounded to the south by Félix E.Lavoie, to the east by lot 52, to the north ami 374 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 21 janvier 1961, Tonus 98, N° S nord et il l'ouest par lu rivière Jaune.Taxes municipal* s: $42.03; taxes scolaires: $5.90.Total: $47.99.Comme appartenant à John Scliulman.\u2014 Partie «lu lot (94) quutrc-viiigt-qiiutorze du cadastre de Suint-Dunstun, borné au nord par M.Jobin, à l'ist par M.Simmops à l'ouest pur M.Dub au luir the north by Antonio Jobin to the south by Gaudios Bédard.Municipal taxes: $6.97.Total: $0.97.As belonging to Armand Rousseau.\u2014 Part of lot (294) two hundred und ninety-four of the cadastre of Suint-Ambroise, bounded to the east by the public road, to the north and southwest by Kil.Rousseau or representatives and to the south by Joseph Drolet.Municipal taxes: $50.25.Total: 850.25, As belonging to Roméo Noël.\u2014 Part of lot (270-9) nine of the subdivision of lot two hundred and seventy, of the cadastre for the parish of Saint-Ambroise, measuring 42 feet in width to the south, 118 feet in width to the north by 125 feet in depth, plus an other part of lot 270-9 measuring 192 feet in width by 200 fcet in «lepth, bounded to the south by the public roa«l t«> the north by Cléophas Dion to the southwest by Louis Gagnon or representatives ami to the northeast bv J.-Dion or representatives.Municipal taxes': $32.37.Total: $32.37.As belonging to William Andrews.\u2014 Part of lot number (10,5) one hundred ami five of the cadastre for the parish of Saint-Ambroise, measuring 100 feet in vie It b by about 11 urpents in depth, bounded to the northwest by the public roa«l.to the southeast by the Concession Line, to the northeast by Paul Tillman, to the southwest bv Maurice Labranehe or representatives.Municipal taxes: 827.05.Total: $27.05.As belonging to Maurice Bell.\u2014 The lots numbers (270-30-21) twenty-one of the r«'«livisum of the subdivision thirty-six of lot two hundred and seventy and (270-37-42) fourty-two of the redivision of the subdivision thirty-seven of lot two hundred ami seventy of the cadastre for the parish of Saint-Ambroise.Municipal tuxes: $5.01.Total: $5.61.As belonging to Mrs.Cyrille Bruyère.\u2014 Part of lot number (298) two hundred ami ninety-eight of the cadastre for the parish of Saint-Ambroise, measuring 150 feet in width by 250 feet in depth, bounded to the north by a street, to the south bv Albert Duigle.Municipal tuxes: $48.12.Total: $48.12.Comme appurtenant ù Bernard Gagnon.\u2014 Part of lot (433) four hundred and thirty-three of the cadustre of Saint-Ambroise, measuring 100 feet in width by 100 feet in depth, bounded to the northeast by Adrien Bcaulieu, to the southwest by the lot 423, ami in front by a street Municipal taxes: $18.28.Total: $18.28.As belonging to Mrs.J.-B.Martel.\u2014 Part of lot number (270-1) one of the subdivision of lot two hundred and seventy of the cadastre for the parish of Saint-Ambroise, measuring 100 feet in width by 177 fcet in depth, bounded to the southwest by the public road, to the northeast by Adrien Morasse, to the northwest by Man el Martel, to the southeast by Alphonse Tremblay or representatives.Municipal taxes: $33>-.Total: $33.82. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.January 21st, 10Q1, Vol 93, No.S 377 ComtM appartenant à Mme J.-Cliarles Marte.Les lots numéros (S 10 et S17) huit cent cent seize et huit cent dix-sept du cadastre de I' Viicienne-Lorcttc.Taxes munieipules: $33.03.Total! $33.93.Comme appartenant à M.Charles Martel.\u2014 I.c lot (818) huit cent dix-huit du cadastre pour la paroisse de l'Anciennc-IiOrette.Taxes municipales: $13.95.Total: $13.95 tomme appartenant à Mme Lucien Milhom-ine.- Les lots numéros (270-25-13) treize de la redivision de la subdivision vingt-cinq du lot deux cent soixuntc-dix du cadastre de Saint-Ambroise et (270-25-17) dix-sept de la redivision de la subdivision vingt-cinq du lot deux cent loixante-dil du cadastre de Saint-Ambroise.Taxes municipales: $10.17.Total: $10.17.Comme appartenant ù Hervé Morand.\u2014Le lot numéro (818) huit cent quarante-huit du cadastra pour la paroisse de l'Auciennc-Lorette.Taxes municipales: 88.03.Totals $8.03.Comme appartenant à Ovilu Mord.\u2014 Partie du lot (903) trois cent trois du cadastre de Saint-Ambroise, mesurant 300 pieds de largeur sur l'arpent de profondeur, borné au nord-st par T.Hunter, au sud-ouest par Simonne Paillette, an sud par Elzéar Beaumont, au nord par Xavier Racine.Taxes municipales: 822.10.Total: 122.40.Comme appartenant à* Joseph Rouillard.\u2014 Partie «lu lot (107) cent sept du cadastre pour la paroisse de Saint-Ambroise, mesurant 1 arpent de largeur sur 15 arpents de profondeur, borné an sud par la ligne de concession, au nord par le Camp Valcartier, au nord-est par Isale Giguère, au sud-ouest par M.Filion.Taxes munieipules: $15.22.Total: $15.22.Comme appartenant à Madame H.-B.Vail-lancourt\u2014 Partie du lot (433) quatre cent trente-troin «lu cadastre de Saint-Ambroise.mesurant 93 pieds au sud, 113 pieds nu nord, borné au sud par une rue, au nord par l'avenue des Bouleaux au sud-ouest par J.-P.Gobeil, au nord-est une rue.Taxes municipales: $23.08.Total: par une rue.Taxes municipales: $23.08.Total: $23.08.Comme appartenant à Antoine Yerreault.\u2014 Partie du lot numéro (2S0) deux cent quatre-vingl du cadastre de Saint-Ambroise.mesurant 100 pi \"
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.